Home Page
|
What's New
|
Photos
|
Histories
|
Headstones
|
Reports
|
Surnames
Search
First Name:
Last Name:
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Suomalainen
Svenska
Agnes Mychell Michell
1511 - 1553 (42 years)
Submit Photo / Document
Individual
Descendants
Relationship
Timeline
Submit Photo / Doc
Worksheet
Family
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Agnes Mychell Michell
[1]
b. 1511 d. 1553
George Woodward
b. 1499 d. Mar 1552
2
John Woodward
[1.1]
b. 1525 d. 8 Jul 1566
Margaret Bulstrode
b. 1519 d. 1560
3
Richard Woodward
[1.1.1]
b. 1545
Anne Borden
b. Abt 1547 d. 28 Jan 1580
4
Richard Woodward
[1.1.1.1]
b. Abt 1575
Frances Rose Marden
b. Abt 1575
5
Nathaniel Woodward
[1.1.1.1.1]
b. Abt 1590 d. 11 May 1685
Margaret Hulins
b. 15 Jul 1595 d. 28 Aug 1684
6
Nathaniel Woodward
[1.1.1.1.1.1]
b. 1613 d. 1694
Mary Jackson
b. 26 Nov 1618
7
Child Woodward
[1.1.1.1.1.1.1]
b. Bef 2 Aug 1642
7
Elisha Woodward
[1.1.1.1.1.1.2]
b. 15 Apr 1644
7
Israel Woodward
[1.1.1.1.1.1.3]
b. 1648 d. 15 Jun 1674
Jane Godfrey
b. 1652 d. 17 Mar 1736
8
Elizabeth Woodward
[1.1.1.1.1.1.3.1]
b. 15 Jun 1670 d. 7 Aug 1753
Robert Taft Jr
b. Abt 1674 d. 29 Apr 1748
9
Robert Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.1]
b. 24 Dec 1697 d. 6 Mar 1776
Mary Chapin
b. 30 Apr 1700 d. 22 Jan 1768
10
Bethiah Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.1.1]
b. 21 Dec 1721 d. 30 May 1741
10
Elizabeth Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.1.2]
b. 18 Jun 1723 d. 1779
10
Deborah Keith
[1.1.1.1.1.1.3.1.1.3]
b. 20 Feb 1728 d. 11 Apr 1806
10
Seth Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.1.4]
b. 27 Oct 1729 d. 15 Feb 1794
10
Jesse Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.1.5]
b. 4 Apr 1731 d. 1753
10
Abigail Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.1.6]
b. 20 Jan 1737
10
Ebenezer Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.1.7]
b. 8 Aug 1732 d. 3 Oct 1836
Polly Hayward
b. 10 Oct 1760 d. 15 Aug 1848
11
Enos Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.1.7.1]
b. 8 Dec 1779 d. 29 Dec 1812
11
Betsey Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.1.7.2]
b. 11 Jun 1781
11
Putman Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.1.7.3]
b. 5 Aug 1783 d. 20 Feb 1810
Abigail Benson
b. 13 Feb 1787
12
Mary Ann Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.1.7.3.1]
b. 23 Oct 1807
11
Polly Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.1.7.4]
b. 20 Jun 1785
11
Salley Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.1.7.5]
b. 21 Oct 1787 d. 7 Aug 1855
Jared Benson
b. 3 Feb 1785 d. 31 Jul 1854
12
James Sulliven Benson
[1.1.1.1.1.1.3.1.1.7.5.1]
b. 19 Sep 1808 d. 3 Jan 1833
12
Putman Taft Benson
[1.1.1.1.1.1.3.1.1.7.5.2]
b. 28 Oct 1814 d. 24 Apr 1834
12
Jared Benson
[1.1.1.1.1.1.3.1.1.7.5.3]
b. 8 Nov 1821 d. 18 May 1894 [
=>
]
12
Sylvanus Holbrook Benson
[1.1.1.1.1.1.3.1.1.7.5.4]
b. 23 Jun 1828 d. 1878 [
=>
]
11
Chloe Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.1.7.6]
b. 7 Nov 1789
11
Deborah Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.1.7.7]
b. 21 Feb 1791 d. 14 Feb 1813
11
Leonard Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.1.7.8]
b. 17 Jun 1794 d. 25 Sep 1872
Martha Comstock
b. 17 Nov 1798 d. 14 May 1853
12
Hannah Mariah Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.1.7.8.1]
b. 11 Jul 1824 d. 31 Jul 1844
12
Enos Nelson Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.1.7.8.2]
b. 12 Aug 1826
12
Leonard Almond Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.1.7.8.3]
b. 22 Jul 1828 d. 29 Jul 1857
12
Edward Henry Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.1.7.8.4]
b. 1 Jul 1830
11
Phila Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.1.7.9]
b. 25 Mar 1796 d. 26 Mar 1813
11
Ellis Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.1.7.10]
b. 23 May 1796 d. 27 Aug 1851
+
Aseneth Boyden
b. 10 Sep 1794 d. Apr 1886
11
Nancy Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.1.7.11]
b. 14 Aug 1801 d. 14 Jan 1849
9
Israel Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2]
b. 26 Apr 1699 d. 19 Sep 1753
Mercy Aldrich
b. 21 Jun 1700 d. Aft 19 Sep 1753
10
Huldah Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1]
b. 28 Jun 1718 d. 2 Jul 1799
David Daniels
b. 4 Jul 1710 d. 21 May 1776
11
Ruth Daniels
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.1]
b. 13 Jul 1738 d. 26 Sep 1798
Jonathan Wheelock
b. 8 Sep 1731 d. 1774
12
Eleazer Wheelock
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.1.1]
b. 15 Jul 1756 d. 1841
12
Dole Wheelock
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.1.2]
b. 29 May 1758
12
Susannah Wheelock
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.1.3]
b. 23 Feb 1760 d. 2 May 1776
12
Lyman Wheelock
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.1.4]
b. 30 Nov 1761 d. 29 Mar 1848
12
Alphaeus Wheelock
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.1.5]
b. 17 Dec 1763
12
Willard Wheelock
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.1.6]
b. 19 Jun 1768 d. 29 Mar 1823
12
Deobrah Wheelock
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.1.7]
b. 17 Dec 1765 d. 3 Aug 1846 [
=>
]
Abraham Staples
b. 4 Apr 1731 d. 20 Oct 1803
12
Ruth Staples
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.1.8]
b. 22 Feb 1775 d. 10 Aug 1851 [
=>
]
12
Lendol Staples
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.1.9]
b. 1777
12
Susannah Staples
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.1.10]
b. 21 Jul 1780 d. 11 Feb 1818
11
Daniel Daniels
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.2]
b. 4 Nov 1740 d. 24 May 1832
Ruth Aldrich
b. 29 Jun 1741 d. 15 Jul 1801
12
Rachael Daniels
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.2.1]
b. 24 Dec 1767 d. 11 Aug 1846
12
Nathan Daniels
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.2.2]
b. 1769 d. 10 May 1839
12
Dianah Daniels
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.2.3]
b. 1774
12
Hulda Daniels
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.2.4]
b. 1776
12
Adolpheus Daniels
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.2.5]
b. 1778
12
Waite Daniels
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.2.6]
b. 1780
+
Nancy Thayer
b. Abt 1743 d. 10 Mar 1803
11
Molly Daniels
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.3]
b. 1 Oct 1741 d. 13 Apr 1793
Seth Kelley
b. 26 Nov 1730 d. 29 Apr 1799
12
Seth Kelley
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.3.1]
b. 10 Sep 1762 d. 27 Sep 1850
12
Mehitable Kelley
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.3.2]
b. 30 Apr 1765 d. 4 Nov 1798
12
Lettice Kelley
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.3.3]
b. 9 Jan 1768 d. 1 Feb 1843
12
Willis Kelley
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.3.4]
b. 14 Jan 1770 d. 23 Dec 1826
12
Moses Kelley
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.3.5]
b. 19 Oct 1771 d. 14 Sep 1776
12
Waite Kelley
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.3.6]
b. 12 Aug 1773 d. 7 Mar 1781
12
Asa Kelley
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.3.7]
b. 24 Mar 1775 d. 29 Apr 1852
12
John Kelley
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.3.8]
b. 12 Dec 1776 d. 17 Aug 1866
12
Daniel Kelley
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.3.9]
b. 23 Jul 1778 d. 23 Apr 1825
12
Mary Kelley
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.3.10]
b. 6 Jul 1780 d. 26 Feb 1802
12
Mark Kelley
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.3.11]
b. 1783 d. 12 Feb 1852
12
Hulda Kelley
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.3.12]
b. 1 Mar 1785 d. 29 Mar 1785
12
David Kelly
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.3.13]
b. 1786
11
Azor Daniels
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.4]
b. 20 Feb 1743 d. 19 Sep 1748
11
Chloe Daniels
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.5]
b. 13 Sep 1745 d. 19 May 1823
Seth Davenport
b. 2 Nov 1739 d. 28 Mar 1813
12
Anna Davenport
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.5.1]
b. 8 Sep 1765 d. 1 Aug 1842 [
=>
]
12
David Davenport
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.5.2]
b. 17 Jan 1767
12
Mary Davenport
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.5.3]
b. 30 Sep 1768
12
Rebecca Davenport
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.5.4]
b. 9 Apr 1770 d. 15 May 1794
12
Samuel Daniels Davenport
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.5.5]
b. 14 Oct 1772 d. 13 Feb 1802
12
Chloe Davenport
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.5.6]
b. 23 Mar 1774 d. 5 Mar 1808
12
Seth Davenport
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.5.7]
b. 13 Jan 1775 d. 22 Apr 1843
12
Benjamin Davenport
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.5.8]
b. 10 Jul 1780 d. 14 Jul 1862
11
Matilda Daniels
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.6]
b. 16 Sep 1747
John Gould
b. Abt 1758
12
Mary Gould
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.6.1]
b. 1779 d. 27 May 1854
11
David Daniels
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.7]
b. 10 Nov 1749 d. 30 Apr 1811
+
Olive Adams
b. 1 Jan 1755 d. 16 Sep 1832
11
Huldah Daniels
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.8]
b. 6 Jan 1752 d. 26 Jun 1836
Silas Penniman
b. 20 Aug 1751 d. 12 May 1777
12
Scammell Penniman
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.8.1]
b. 12 Oct 1772
12
Rhene Penniman
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.8.2]
b. 27 Jan 1774
12
Amos Penniman
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.8.3]
b. 9 Oct 1775
12
Silas Penniman
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.8.4]
b. 12 Aug 1777 d. 1820
Henry Dearth
b. 6 Jun 1741 d. 24 Jun 1804
12
Ruth Dearth
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.8.5]
b. 13 Jul 1787
12
Irene Dearth
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.8.6]
b. 7 Apr 1789
12
June Dearth
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.8.7]
b. 7 Apr 1789
12
Leonard Dearth
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.8.8]
b. 30 Oct 1791 d. 3 Feb 1880
12
Mercy Dearth
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.8.9]
b. 10 Sep 1793
11
Moses Daniels
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.9]
b. 25 Feb 1753
Abigail Aldrich
b. 25 Feb 1761 d. 5 Jul 1834
12
Cyrena Daniels
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.9.1]
b. 26 Sep 1782
12
Salley Daniels
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.9.2]
b. 27 Nov 1784 d. 6 Sep 1842
12
Abigail Daniels
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.9.3]
b. 15 Nov 1786
12
Elbridge C Daniels
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.9.4]
b. 28 Nov 1788
12
Kelly Daniels
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.9.5]
b. 23 Sep 1791 d. 30 Dec 1839
11
Clotilda Daniels
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.10]
b. 19 Sep 1755 d. Abt 1813
Sherebiah Baker
b. 18 Mar 1747 d. May 1823
12
Marshal Baker
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.10.1]
b. 8 Nov 1774 d. 20 Oct 1848
12
Phila Baker
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.10.2]
b. 10 Jul 1773
12
Marshall Baker
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1.10.3]
b. 1779
10
Priscilla Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.2]
b. 15 Aug 1721 d. Jan 1760
Moses Wood
b. 3 Apr 1712 d. Apr 1780
11
Mary Wood
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.2.1]
b. 3 Mar 1740 d. 17 Apr 1841
11
Prissella Wood
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.2.2]
b. 18 May 1741 d. 18 May 1741
11
Jerusha Wood
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.2.3]
b. Abt 1744 d. 27 Apr 1790
11
Rachel Wood
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.2.4]
b. 9 Jun 1746
11
Moses Wood
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.2.5]
b. Abt 1748
11
Susanna Wood
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.2.6]
b. Abt 1748
11
Daniel Wood
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.2.7]
b. 10 Mar 1757
11
Hezekiah Wood
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.2.8]
b. 14 Jan 1760 d. 26 May 1811
11
Rhoda Wood
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.2.9]
b. 13 Apr 1762
10
Israel Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.3]
b. 23 Apr 1723 d. 1775
Martha Smith
b. 1722
11
Israel Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.3.1]
b. 12 Dec 1743
11
Amariah Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.3.2]
b. 18 Apr 1746 d. 1770
11
Oliver Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.3.3]
b. 4 Feb 1750
11
Elizabeth Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.3.4]
b. 27 Jul 1753
11
Marce Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.3.5]
b. 16 Jan 1757
10
Jacob Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.4]
b. 22 Apr 1725 d. 15 Mar 1802
Esther Marsh
b. 28 Jun 1726 d. 14 Mar 1802
11
Esther Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.4.1]
b. 9 Jan 1747 d. 3 Feb 1834
James Taft
b. 9 Apr 1738 d. 14 Jan 1826
12
Lucy Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.4.1.1]
b. 22 Nov 1769 d. 29 Jul 1845 [
=>
]
12
Zilpha Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.4.1.2]
b. 1 Jul 1772 d. 24 Feb 1848 [
=>
]
12
Irena Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.4.1.3]
b. 25 Oct 1774 d. 29 May 1790
12
Ezekial Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.4.1.4]
b. 21 Jan 1777 d. 24 Apr 1841
12
James Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.4.1.5]
b. 13 Jun 1780
12
Luke Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.4.1.6]
b. 3 Jun 1783 [
=>
]
12
Esther Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.4.1.7]
b. 5 Aug 1786 d. 10 Aug 1858 [
=>
]
12
Moses Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.4.1.8]
b. 14 Jul 1788 d. 26 Jun 1810
12
Abigail Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.4.1.9]
b. 24 Jan 1791 d. 15 May 1837 [
=>
]
11
Timothy Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.4.2]
b. 3 Apr 1750 d. 30 Nov 1808
Priscilla Taft
b. 30 Apr 1749 d. 12 Sep 1833
12
Marcy Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.4.2.1]
b. 28 Sep 1771 d. 1 Aug 1848
12
Josiah Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.4.2.2]
b. 3 May 1774
12
Abigail Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.4.2.3]
b. 14 Jan 1777 d. 17 Dec 1832 [
=>
]
12
Polly Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.4.2.4]
b. 1779 d. 5 Sep 1785
12
Timothy Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.4.2.5]
b. 1782 d. 5 Jan 1818 [
=>
]
12
Joseph Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.4.2.6]
b. 1784
12
Jonas Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.4.2.7]
b. 1786
12
Polly Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.4.2.8]
b. 1788 d. 1859
11
Jacob Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.4.3]
b. 1 Dec 1751 d. 30 May 1823
Mary Taft
b. 14 Feb 1753 d. 19 Jul 1832
12
Lois Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.4.3.1]
b. 27 Aug 1780 d. 27 Apr 1854 [
=>
]
12
Hannah Margaret Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.4.3.2]
b. 28 Nov 1782 d. 2 Apr 1857 [
=>
]
12
Elisabeth Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.4.3.3]
b. 8 Nov 1784 [
=>
]
12
Mary Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.4.3.4]
b. 16 Mar 1786 d. 25 Feb 1860
12
Charlotte Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.4.3.5]
b. 25 Feb 1789
12
John Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.4.3.6]
b. 3 Dec 1792 d. 29 May 1826 [
=>
]
12
Orsmus Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.4.3.7]
b. 1 Jan 1795
11
Abigail Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.4.4]
b. 5 Oct 1754 d. 12 Aug 1775
Barzillai Taft
b. 3 Nov 1750 d. 21 Jan 1839
12
Eunice Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.4.4.1]
b. 28 Jan 1775 d. 30 May 1861 [
=>
]
11
Lois Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.4.5]
b. 28 Apr 1757 d. 10 Feb 1792
Caleb Farnum
b. 9 Nov 1753 d. 3 Jan 1829
12
Royal Farnham
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.4.5.1]
b. 28 Nov 1775 d. 3 Sep 1845
12
Easman Farnum
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.4.5.2]
b. 22 Dec 1777 [
=>
]
12
Caleb Farnum
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.4.5.3]
b. 15 Jul 1781 d. 16 Jun 1863 [
=>
]
12
Clarissa Farnam
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.4.5.4]
b. 22 Aug 1784
11
Mercy Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.4.6]
b. 5 Mar 1758 d. 18 Feb 1843
Otis Russell
b. 9 Dec 1733
12
Meribah Russell
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.4.6.1]
b. 1805 d. Aft 1860
11
Israel Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.4.7]
b. 1 Mar 1761 d. 24 Apr 1842
Submit Read
b. 21 Jun 1763 d. 17 May 1841
12
Ruth Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.4.7.1]
b. 5 Jan 1783 [
=>
]
12
Clarisa Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.4.7.2]
b. 5 Mar 1786
12
Elzaphan Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.4.7.3]
b. 15 Feb 1788 d. 23 Mar 1847 [
=>
]
12
Abigail Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.4.7.4]
b. 9 Feb 1790 d. 5 Jun 1791
12
Laurana Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.4.7.5]
b. 13 May 1792 [
=>
]
12
Lydia Mariah Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.4.7.6]
b. 10 Jul 1794 [
=>
]
12
Cyrus Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.4.7.7]
b. 3 Feb 1797 [
=>
]
12
Louis Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.4.7.8]
b. 25 Apr 1801
11
Eastman Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.4.8]
b. 16 Jun 1763 d. 29 Apr 1829
Chloa Taft
b. 25 Nov 1763 d. 4 May 1783
12
Eastman Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.4.8.1]
b. 2 May 1783 d. 8 Aug 1857
Hannah Taft
b. 1 Nov 1763 d. 3 Jul 1832
12
Chloe Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.4.8.2]
b. 7 Jul 1785 d. 25 Apr 1826 [
=>
]
12
Ezra Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.4.8.3]
b. 6 Mar 1793 d. 19 Feb 1808
10
Hannah Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.5]
b. 16 Nov 1726 d. 15 Mar 1802
Elijah Clarke Benjamin
b. 8 Jun 1725 d. 1768
11
Elias Benjamin
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.5.1]
b. 4 May 1750 d. 8 Apr 1823
Rhoda Paddock
b. 9 Sep 1785 d. 5 Jun 1858
12
Deborah Benjamin
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.5.1.1]
b. 25 Apr 1803 d. 6 Dec 1871
12
Ezra H. Benjamin
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.5.1.2]
b. 21 May 1804 d. 20 Jul 1876
12
Edmund Benjamin
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.5.1.3]
b. 28 Jan 1806 d. 25 Nov 1887
12
Robert L Benjamin
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.5.1.4]
b. 14 Jun 1808 d. 20 Jul 1892
12
Hannah Almedia Benjamin
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.5.1.5]
b. 29 Sep 1810 d. Abt 1870
12
John Mills Benjamin
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.5.1.6]
b. 5 Jun 1813 d. 1849
12
Isaac Paddock Benjamin
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.5.1.7]
b. 21 Jul 1815 d. 5 Apr 1892
12
Mary E Benjamin
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.5.1.8]
b. 1 Sep 1817 d. 3 Dec 1819
12
William F Benjamin
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.5.1.9]
b. 18 Apr 1820 d. 10 Aug 1869
12
David E Benjamin
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.5.1.10]
b. 1 May 1822 d. 25 Aug 1890
12
Mary Elizabeth Benjamin
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.5.1.11]
b. 24 Jun 1824 d. 2 Oct 1894
12
Sidney S Benjamin
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.5.1.12]
b. 19 Jul 1826 d. 7 May 1862
12
Jane Ann Benjamin
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.5.1.13]
b. 7 Dec 1829 d. 29 Mar 1915
11
Chester Benjamin
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.5.2]
b. 9 Feb 1751 d. 1830
11
William Benjamin
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.5.3]
b. 6 Mar 1753
11
Captain Elijah Taft Benjamin
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.5.4]
b. 27 Dec 1755 d. 17 Jun 1819
Elizabeth Paddock
b. 1 Nov 1762 d. 26 Apr 1822
12
Elias Paddock Benjamin
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.5.4.1]
b. 6 May 1783 d. 27 Nov 1866
12
David Benjamin
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.5.4.2]
b. 18 May 1785 d. 18 Feb 1825
12
Elijah E Benjamin
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.5.4.3]
b. 26 Oct 1788 d. 19 May 1880
12
Charles Benjamin
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.5.4.4]
b. 7 Oct 1789 d. 10 Feb 1874
12
Daughter Benjamin
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.5.4.5]
b. 1791
12
Frederick B Benjamin
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.5.4.6]
b. 1794 d. 1868
12
Aaron Benjamin
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.5.4.7]
b. 1801 d. 4 Feb 1883
12
Loretta Benjamin
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.5.4.8]
b. 5 Feb 1804 d. 8 Feb 1886
11
Cyrus Benjamin
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.5.5]
b. 7 Jul 1762 d. 19 Jul 1817
Rhoda Maria Dibble
b. 7 Oct 1771 d. 8 Dec 1817
12
Mary Crosby Benjamin
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.5.5.1]
b. 11 Oct 1790
12
Hannah Benjamin
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.5.5.2]
b. 2 Jan 1792 d. 1 Jan 1794
12
David C Benjamin
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.5.5.3]
b. 7 Nov 1793
12
Anna Benjamin
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.5.5.4]
b. 22 Jan 1796 d. 9 Oct 1817
12
Annis Benjamin
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.5.5.5]
b. 10 Feb 1798 d. 16 Jun 1869
12
Peter Benjamin
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.5.5.6]
b. 14 Feb 1800 d. 2 Sep 1839
12
Cyrus Benjamin
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.5.5.7]
b. 11 Jul 1801
12
Nathaniel Benjamin
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.5.5.8]
b. 23 Jun 1803
12
Charles J Benjamin
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.5.5.9]
b. 17 Feb 1805 d. 1877
12
Elijah Benjamin
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.5.5.10]
b. 28 May 1807
12
Eliza "Wealthy" Benjamin
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.5.5.11]
b. 28 May 1807 d. 28 Jan 1862
12
Joel Samuel Benjamin
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.5.5.12]
b. 17 Apr 1809 d. 4 Feb 1882
12
Catherine E Benjamin
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.5.5.13]
b. 18 Jan 1814
12
Cyrus S Benjamin
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.5.5.14]
b. 13 Jun 1816
12
Daniel W Benjamin
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.5.5.15]
b. 13 Jun 1816 d. 2 Jun 1892
11
Hannah Benjamin
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.5.6]
b. 7 Jul 1762 d. 13 May 1840
11
Mary Benjamin
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.5.7]
b. 7 Jul 1768 d. 5 Feb 1849
11
Darius Benjamin
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.5.8]
b. 17 Jan 1758 d. 12 Feb 1850
10
Elisha Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.6]
b. 3 May 1728 d. 3 Mar 1791
Experience Taft
b. 7 Apr 1733 d. 15 Mar 1817
11
Hannah Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.6.1]
b. 16 Mar 1758
11
Elisha Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.6.2]
b. 4 Mar 1761 d. 16 Jan 1820
Mary Sadler
b. 15 Aug 1768 d. 1800
12
Hiram Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.6.2.1]
b. 2 Apr 1789 d. 15 Nov 1794
12
Elisha Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.6.2.2]
b. 23 Jul 1791 d. 26 Feb 1858
12
Ormon Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.6.2.3]
b. 11 Nov 1793 d. 23 Jan 1794
12
Mary Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.6.2.4]
b. 23 May 1795 d. 23 Feb 1875
11
Sarah Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.6.3]
b. 21 Mar 1763 d. 11 Oct 1835
Ezra Wood, Jr
b. 12 Mar 1759 d. 10 May 1837
12
Ezra Wood
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.6.3.1]
b. 25 Oct 1781
12
Experience Wood
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.6.3.2]
b. 16 Mar 1783 d. 14 Oct 1818
12
Sarah Wood
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.6.3.3]
b. 7 Aug 1784
12
Elisha Wood
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.6.3.4]
b. 24 Apr 1786 d. 19 Oct 1797
12
Jonathan Wood
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.6.3.5]
b. 8 Oct 1787 d. 26 Feb 1846
12
Anna Wood
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.6.3.6]
b. 31 Aug 1789 d. 20 Mar 1832
12
Chapin Wood
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.6.3.7]
b. 2 Apr 1792
12
Lucy Wood
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.6.3.8]
b. 11 Nov 1794 d. 10 Dec 1826
12
Silva Wood
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.6.3.9]
b. 29 Apr 1796
12
Silva Wood
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.6.3.10]
b. 29 Apr 1796
12
Phila Wood
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.6.3.11]
b. 5 Jul 1798
12
Elisha Wood
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.6.3.12]
b. 7 Nov 1800
12
Simeon Wood
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.6.3.13]
b. 5 Jan 1805
11
Israel Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.6.4]
b. 12 Feb 1766
11
Joseph Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.6.5]
b. 15 Sep 1768 d. Aft 29 Sep 1815
Sarah Farrar
b. 14 Sep 1764 d. 5 Aug 1810
12
Experience
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.6.5.1]
b. 5 Feb 1792
12
Amiel F Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.6.5.2]
b. 1 Oct 1794 d. 29 Nov 1869
12
Roxalana Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.6.5.3]
b. 22 Jan 1798
12
Sofrona Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.6.5.4]
b. 17 Jun 1800
12
Esquire Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.6.5.5]
b. 28 Apr 1803 d. 11 Mar 1865
12
Deborah R Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.6.5.6]
b. 6 Jan 1806
+
Marcy Stockwell
b. Abt 1794
10
Mercy Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.7]
b. 7 Apr 1733 d. 27 Mar 1801
Benjamin Green
b. 11 Aug 1734 d. 16 Aug 1797
11
Benjamin Green
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.7.1]
b. 6 Jan 1754
11
Israel Green
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.7.2]
b. 22 Jun 1755
11
Margery Green
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.7.3]
b. 1 Feb 1758 d. 22 Sep 1838
Josiah Taft
b. 28 Oct 1752 d. 8 Jan 1846
12
Josiah Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.7.3.1]
b. 10 Apr 1778 d. 30 Dec 1790
12
Lydia Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.7.3.2]
b. 13 Feb 1780
12
Israel Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.7.3.3]
b. 30 Jul 1782 d. 10 Apr 1840 [
=>
]
12
Benjamin Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.7.3.4]
b. 3 Aug 1784 d. 13 May 1863
12
Mercy Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.7.3.5]
b. 1786 d. 12 Jun 1803
12
Polly Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.7.3.6]
b. 23 Sep 1790
12
Andre Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.7.3.7]
b. 25 Jun 1792 d. 26 Jun 1850 [
=>
]
12
Judson Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.7.3.8]
b. 14 Feb 1793 d. 26 Jan 1891
12
Eunice Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.7.3.9]
b. 14 Mar 1795
12
Harry Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.7.3.10]
b. 5 Mar 1797
12
Guilford Hodges Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.7.3.11]
b. 1 Jan 1799 d. 22 Nov 1816
11
Marcy Green
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.7.4]
b. 1 Jan 1760 d. 8 Jun 1815
Cummings Taft
b. 27 Aug 1770 d. 22 Jun 1841
12
Ezra Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.7.4.1]
b. 13 May 1797 d. 16 Nov 1878 [
=>
]
12
Benjamin Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.7.4.2]
b. 10 Aug 1798 d. 29 May 1799
12
Benjamin Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.7.4.3]
b. 6 May 1800 d. 17 Oct 1828 [
=>
]
12
Hannah G Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.7.4.4]
b. 18 May 1802 d. 8 Jan 1843 [
=>
]
11
Hannah Green
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.7.5]
b. 2 Apr 1763
11
Rachel Green
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.7.6]
b. 27 Aug 1765
11
Samuel Green
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.7.7]
b. 14 Mar 1767
10
Stephen Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.8]
b. 21 Aug 1734 d. 3 Feb 1803
Anna Taft
b. 14 Apr 1748 d. 3 Apr 1830
11
Lydia Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.8.1]
b. 13 Oct 1766 d. 13 Jan 1847
11
Hazeltine Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.8.2]
b. 6 Jan 1769 d. 18 Jul 1856
11
Gravenor Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.8.3]
b. 1773 d. 1838
11
Marcy Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.8.4]
b. 5 Sep 1775
11
Ephraim Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.8.5]
b. 18 Aug 1780
Elisabeth Taft
b. 8 Nov 1784
12
Mary Ann Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.8.5.1]
b. 22 May 1805
12
Ephriam Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.8.5.2]
b. 8 Feb 1807
11
Lovice Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.8.6]
b. 1 Jul 1783
11
Anna Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.8.7]
b. 29 Nov 1784
11
Stephen Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.8.8]
b. 12 Dec 1787
11
Adolphas Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.8.9]
b. 2 Oct 1791
10
Samuel Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.9]
b. 23 Sep 1735 d. 2 Aug 1816
Mary Murdock
b. 3 Jan 1742 d. 26 Mar 1785
11
Frederick Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.9.1]
b. 19 Jun 1759 d. 10 Feb 1846
Abigail Wood
b. 29 Aug 1761 d. 2 Jun 1851
12
Samuel Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.9.1.1]
b. 12 Dec 1782 d. 8 Feb 1842
12
Murdock Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.9.1.2]
b. 8 Dec 1784 d. 6 Aug 1820
12
Calista Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.9.1.3]
b. 31 Jan 1787 d. 11 Dec 1864
12
Clarinda Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.9.1.4]
b. 28 Feb 1789 d. 11 Apr 1877 [
=>
]
12
Frederic A Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.9.1.5]
b. 7 Apr 1790 d. 18 Sep 1837
12
Nabby Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.9.1.6]
b. 7 Jun 1793 d. 19 Jul 1880
12
Harriet Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.9.1.7]
b. 25 Jul 1795 d. 3 Sep 1852
12
Parla Parilla Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.9.1.8]
b. 5 Mar 1798 d. 26 Sep 1852
12
Ezra Wood Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.9.1.9]
b. 26 Aug 1800 d. 8 Feb 1885
12
Mary Ann Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.9.1.10]
b. 11 Sep 1803 d. 7 Sep 1850
12
Margaret Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.9.1.11]
b. 31 May 1806 d. 23 Jan 1891
11
Sibbel Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.9.2]
b. 19 Aug 1760 d. 28 Sep 1761
11
Lyman Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.9.3]
b. 14 Mar 1762 d. 24 Jul 1833
11
Mercy Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.9.4]
b. 23 Apr 1765 d. 25 Apr 1768
11
Willard Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.9.5]
b. 30 Oct 1766 d. 14 Sep 1845
11
Parley Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.9.6]
b. 20 Jan 1768 d. 13 Apr 1768
11
Merret Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.9.7]
b. 26 Jan 1769
11
Otis Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.9.8]
b. 29 Oct 1771
11
Farla Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.9.9]
b. 24 Mar 1774 d. 6 Apr 1864
11
Washington Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.9.10]
b. 16 Sep 1775
11
Philena Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.9.11]
b. 11 Mar 1781 d. 1814
11
George Washington Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.9.12]
b. 1 May 1783 d. 30 Nov 1824
Experiance Humes
b. 27 May 1750 d. 15 Jan 1837
11
Dandridge Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.9.13]
b. 1 Aug 1787 d. 10 Aug 1832
11
Warner Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.9.14]
b. 15 Sep 1789 d. 3 Aug 1837
11
Experiance Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.9.15]
b. 10 Jun 1791 d. 30 Nov 1863
11
Polley Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.9.16]
b. 18 Mar 1794
10
Margery Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.10]
b. 14 May 1738 d. 20 Jan 1813
Simeon Wood
b. 7 Jan 1732 d. 11 May 1802
11
Stephen Wood
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.10.1]
b. 14 Oct 1761 d. Abt 1820
11
Simeon Wood, Jr
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.10.2]
b. 14 Oct 1761 d. 1819
11
Rhoda Wood
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.10.3]
b. 25 May 1763 d. 8 Apr 1832
11
Jerusha Wood
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.10.4]
b. 28 Jun 1765 d. 8 Apr 1832
Asa Newell
b. 27 Nov 1761 d. 4 Aug 1808
12
Caleb Newell
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.10.4.1]
b. Abt 1786
12
Eabon Carter Newell
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.10.4.2]
b. 17 Nov 1788 d. 3 Mar 1831
12
Matilda Newell
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.10.4.3]
b. 1793 d. 28 Aug 1830
12
Lucretia Newell
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.10.4.4]
b. 24 Sep 1795 d. 29 Dec 1863 [
=>
]
12
Jerusha Newell
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.10.4.5]
b. 7 Nov 1799 d. 31 Oct 1879
12
Asa Newell
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.10.4.6]
b. 31 Aug 1803 d. Apr 1865
11
Caleb Wood
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.10.5]
b. 2 Jun 1767 d. 24 Jun 1769
11
Willis Wood
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.10.6]
b. 14 Jul 1769 d. 5 Oct 1779
11
Nathaniel G Wood
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.10.7]
b. 24 Jul 1771 d. 4 Sep 1847
11
Lois Wood
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.10.8]
b. 8 Nov 1772 d. 20 Apr 1773
11
Eunice Wood
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.10.9]
b. 11 Apr 1773 d. 28 Jun 1791
11
Jesse Wood
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.10.10]
b. 29 Aug 1775 d. Bef 1884
11
Mary Wood
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.10.11]
b. 3 Jan 1778 d. 3 Jan 1868
11
Sibel Wood
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.10.12]
b. 12 Jan 1781 d. Feb 1831
10
Silas Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.11]
b. 17 Dec 1739 d. 10 May 1741
10
Rachel Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.12]
b. 18 Jul 1742 d. 30 Dec 1747
10
Silas Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.13]
b. 5 Nov 1744
Elizabeth Sadler
b. 13 Sep 1754
11
Stephen Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.13.1]
b. 22 Feb 1773 d. 26 Oct 1846
11
Silas Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.13.2]
b. 2 Jun 1775
11
Israel Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.13.3]
b. 22 Sep 1777 d. 19 May 1842
11
Joel Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.13.4]
b. 28 Apr 1780
11
Belzaleel Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.13.5]
b. 28 Jan 1783 d. 15 Apr 1831
11
Otis Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.13.6]
b. 17 Sep 1786 d. 19 Nov 1827
Thankful Benson
b. 29 Aug 1783 d. 11 Apr 1808
12
Tilus Vespasian Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.13.6.1]
b. 4 Jun 1806 d. 22 Feb 1889 [
=>
]
12
Benjamin B Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.13.6.2]
b. 28 Feb 1808
11
Samuel Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.13.7]
b. 18 Oct 1788 d. 20 Oct 1859
11
Elisha Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.13.8]
b. 15 Feb 1791 d. 26 Dec 1849
11
Elizabeth Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.13.9]
b. 2 Feb 1795
10
Phila Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.14]
b. Abt 1748 d. 1794
9
Mary Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.3]
b. 21 Dec 1700 d. 1755
Benjamin Albee
b. 1 Nov 1694 d. 24 Jun 1755
10
Deacon Gideon Albee
[1.1.1.1.1.1.3.1.3.1]
b. 1 Mar 1723 d. 18 Oct 1799
10
Susanna Albee
[1.1.1.1.1.1.3.1.3.2]
b. Abt 1725 d. 8 Aug 1802
10
Jemima Albee
[1.1.1.1.1.1.3.1.3.3]
b. 7 Oct 1731 d. 7 Oct 1782
10
Peter Albee
[1.1.1.1.1.1.3.1.3.4]
b. 19 Jan 1736
10
Stephen Albee
[1.1.1.1.1.1.3.1.3.5]
b. Abt 1740
9
Elizabeth Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.4]
b. 18 Jun 1704 d. 1748
Peter Marvel
b. 1700 d. 26 Sep 1735
10
Margaret Marvel
[1.1.1.1.1.1.3.1.4.1]
b. Abt 1729
10
Tristan Marvel
[1.1.1.1.1.1.3.1.4.2]
b. Abt 1730 d. 29 Feb 1748
9
Alice Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.5]
b. 27 Jun 1707
+
Briggs
b. Abt 1700 d. Aft 1727
9
Eunice Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.6]
b. 20 Feb 1709 d. 27 Feb 1787
Obadiah Walker
b. 9 Oct 1691 d. 9 Jun 1760
10
Benjamin Walker
[1.1.1.1.1.1.3.1.6.1]
b. 30 Sep 1746 d. Bef 23 Nov 1813
9
John Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.7]
b. 18 Dec 1710 d. 19 Apr 1769
Hannah Cheney
b. 13 Feb 1711 d. 22 Feb 1759
10
Eunice Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.1]
b. 18 Jun 1735
Colonel Joseph Reed
b. 6 Mar 1731
11
Nathan Reed
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.1.1]
b. 9 Dec 1754
11
Eunice Reed
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.1.2]
b. 26 Dec 1755
11
Major Cheney Reed
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.1.3]
b. Abt 1759 d. 18 May 1822
11
Joseph Reed
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.1.4]
b. 1 Sep 1760
11
Hannah Reed
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.1.5]
b. 24 Jul 1762
10
Hannah Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.2]
b. 4 Jul 1737 d. 2 Feb 1740
10
John Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.3]
b. 2 Jan 1740 d. 1 Feb 1808
Mary Harwood
b. 10 Jun 1745 d. 2 Jun 1782
11
Susanna Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.3.1]
b. 6 Mar 1763 d. 12 Feb 1846
11
Olive Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.3.2]
b. 11 Apr 1765
11
Margary Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.3.3]
b. 21 Aug 1767
11
Hulda Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.3.4]
b. 7 Apr 1770
10
Hannah Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.4]
b. 5 Jun 1744
10
Bethiah Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.5]
b. 9 Aug 1747
10
Robert Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.6]
b. 21 Jul 1749
Chloe Taft
b. 7 Jun 1753 d. 17 Oct 1843
11
Hannah Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.6.1]
b. 21 Mar 1772 d. 3 Aug 1802
11
Josiah Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.6.2]
b. 6 Jul 1776 d. 1845
11
Abigail Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.6.3]
b. 17 Aug 1778 d. 31 Oct 1850
11
Jesse Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.6.4]
b. 3 Feb 1781 d. 10 Jun 1783
11
Jesse Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.6.5]
b. 30 Apr 1782 d. 15 Oct 1869
11
Chloe Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.6.6]
b. 20 Jan 1786 d. 1809
11
Robert Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.6.7]
b. 26 Nov 1788 d. 16 Apr 1865
10
Josiah Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.7]
b. 29 Nov 1752
10
Mary Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.8]
b. 14 Feb 1753 d. 19 Jul 1832
Jacob Taft
b. 1 Dec 1751 d. 30 May 1823
11
Lois Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.8.1]
b. 27 Aug 1780 d. 27 Apr 1854
Josiah Seagrave
b. 14 Oct 1773 d. 20 Mar 1855
12
Mary Ann Seagrave
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.8.1.1]
b. 17 Nov 1799 d. 10 Feb 1825
12
Jacob Taft Seagraves
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.8.1.2]
b. 8 Apr 1802 d. 24 Sep 1870
12
Henrietta Frost Seagrave
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.8.1.3]
b. 1 Dec 1803 d. 1 Jun 1823
12
Waity Grant Seagrave
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.8.1.4]
b. 23 Sep 1805 d. 27 Jan 1859
12
Edward Seagrave
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.8.1.5]
b. 3 Sep 1807 d. 15 Feb 1873
12
Lois Taft Seagrave
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.8.1.6]
b. 13 Apr 1809 d. 19 Mar 1853
12
Josiah Seagrave, Jr
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.8.1.7]
b. 24 May 1811 d. 21 Jul 1861
12
Malvina Seagrave
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.8.1.8]
b. 2 Apr 1813 d. 16 Dec 1823
12
Caleb Seagrave
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.8.1.9]
b. 8 Feb 1815 d. 14 Nov 1823
12
Son Seagrave
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.8.1.10]
b. 3 May 1817 d. 3 May 1817
12
Daughter Seagrave
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.8.1.11]
b. 3 May 1817 d. 3 May 1817
12
Esborn Seagrave
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.8.1.12]
b. 28 Dec 1818 d. 27 Oct 1856
12
George Augustus Seagrave
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.8.1.13]
b. 6 Jan 1823 d. 15 Nov 1884
11
Hannah Margaret Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.8.2]
b. 28 Nov 1782 d. 2 Apr 1857
Stephen Carpenter
b. 13 Aug 1778 d. 1 Oct 1854
12
Eunice Carpenter
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.8.2.1]
b. Sep 1802 d. Mar 1864
12
Orsmus T Carpenter
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.8.2.2]
b. Jan 1805 d. 4 Apr 1863
12
Joseph Rawson Carpenter
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.8.2.3]
b. 2 Apr 1807 d. May 1839
12
Charlotte Taft Carpenter
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.8.2.4]
b. 4 Feb 1809 d. 5 Sep 1845
12
Charles A Carpenter
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.8.2.5]
b. 11 Feb 1813 d. 12 Aug 1887
12
Mary T Carpenter
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.8.2.6]
b. 1815
12
Hannah Taft Carpenter
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.8.2.7]
b. 20 Aug 1817 d. 17 Dec 1890
12
Nancy Carter Carpenter
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.8.2.8]
b. 5 Jun 1820 d. 15 May 1898
12
Henrietta Carpenter
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.8.2.9]
b. Apr 1823 d. Feb 1847
12
George Carpenter
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.8.2.10]
b. 13 Jan 1825
11
Elisabeth Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.8.3]
b. 8 Nov 1784
Ephraim Taft
b. 18 Aug 1780
12
Mary Ann Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.8.3.1]
b. 22 May 1805
12
Ephriam Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.8.3.2]
b. 8 Feb 1807
11
Mary Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.8.4]
b. 16 Mar 1786 d. 25 Feb 1860
11
Charlotte Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.8.5]
b. 25 Feb 1789
11
John Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.8.6]
b. 3 Dec 1792 d. 29 May 1826
Lucretia Newell
b. 24 Sep 1795 d. 29 Dec 1863
12
Robert Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.8.6.1]
b. 27 May 1819
12
Jacob Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.8.6.2]
b. 19 May 1823
11
Orsmus Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.8.7]
b. 1 Jan 1795
Deborah White
b. 16 Feb 1722 d. 26 Oct 1806
10
Nathan Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.9]
b. 20 Oct 1766
10
Samuel Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.7.10]
b. 6 Feb 1769
9
Jemima Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.8]
b. 1 Apr 1713 d. 14 Oct 1787
Peter White
b. 6 Dec 1714 d. 8 May 1782
10
Joseph White
[1.1.1.1.1.1.3.1.8.1]
b. 25 Jun 1738 d. 1805
10
Bethaih White
[1.1.1.1.1.1.3.1.8.2]
b. 1 Mar 1740 d. 1809
10
Elisabeth White
[1.1.1.1.1.1.3.1.8.3]
b. 13 Dec 1743
10
Peter White
[1.1.1.1.1.1.3.1.8.4]
b. 1746 d. 2 Dec 1821
10
Jemima White
[1.1.1.1.1.1.3.1.8.5]
b. Abt 1754 d. Abt 1782
10
Nathan White
[1.1.1.1.1.1.3.1.8.6]
b. 10 Jan 1755 d. 21 Jan 1828
9
Gideon Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.9]
b. 4 Oct 1715 d. 1761
Elizabeth
b. Abt 1715
10
Nathan Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.9.1]
b. Abt 1735 d. 1 Dec 1741
10
Jemima Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.9.2]
b. 8 Sep 1736 d. 1 Aug 1742
10
Gideon Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.9.3]
b. 10 Nov 1738
10
Timothy Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.9.4]
b. 10 Sep 1740 d. 23 Nov 1741
10
Asa Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.9.5]
b. 8 May 1747 d. 10 Dec 1802
10
Elizabeth Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.9.6]
b. 1 Mar 1750
10
Phineas Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.9.7]
b. 29 Jan 1754 d. 6 Nov 1828
Jemima Thomson
b. 26 Jan 1752 d. 2 Dec 1837
11
Gideon Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.9.7.1]
b. 2 Mar 1776 d. 17 Nov 1859
11
David Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.9.7.2]
b. 1777 d. 1812
11
Mary Susan Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.9.7.3]
b. 1 Dec 1782 d. 28 Nov 1862
11
Cynthia Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.9.7.4]
b. Abt 1780 d. 8 Feb 1877
11
Otis Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.9.7.5]
b. 1785 d. 23 Apr 1855
11
Phineas Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.9.7.6]
b. 1790
11
Crispin Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.9.7.7]
b. 10 Feb 1793 d. 30 Jun 1862
10
Louise Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1.9.8]
b. Jul 1756
7
Nathaniel Woodward
[1.1.1.1.1.1.4]
b. 12 Apr 1646 d. 5 Mar 1722
7
John Woodward
[1.1.1.1.1.1.5]
b. 1650 d. 10 May 1688
7
James Woodward
[1.1.1.1.1.1.6]
b. Abt 1654 d. 3 Oct 1732
7
Robert Woodward
[1.1.1.1.1.1.7]
b. 2 Aug 1654 d. 1744
7
Ezekiel Woodward
[1.1.1.1.1.1.8]
b. Abt 1658 d. Abt 1693
6
Elizabeth Woodward
[1.1.1.1.1.2]
b. 24 Apr 1614
6
John Woodward
[1.1.1.1.1.3]
b. Abt 1615 d. 1688
6
Anne Woodward
[1.1.1.1.1.4]
b. Abt 1616 d. 21 Apr 1630
6
Lambert Woodward
[1.1.1.1.1.5]
b. Bef 5 Oct 1617 d. Abt 1690
6
Robert Woodward
[1.1.1.1.1.6]
b. 1618 d. 21 Nov 1653
Rachel Smith
b. Abt 1620 d. 1695
7
Joseph Woodward
[1.1.1.1.1.6.1]
b. 24 Oct 1641
7
Smith Woodward
[1.1.1.1.1.6.2]
b. 31 Jul 1644 d. 1668
7
Thomas Woodward
[1.1.1.1.1.6.3]
b. 2 Apr 1650 d. 1650
7
John Woodward
[1.1.1.1.1.6.4]
b. 14 Dec 1651 d. 23 Aug 1652
7
Jeremiah Woodward
[1.1.1.1.1.6.5]
b. 28 Aug 1653 d. 26 Nov 1653
6
Prudence Woodward
[1.1.1.1.1.7]
b. Abt 1621
Isaac Anderson
b. Abt 1669 d. Abt 1723
7
William Anderson
[1.1.1.1.1.7.1]
b. Abt 1693 d. 10 Sep 1726
7
Elizabeth Anderson
[1.1.1.1.1.7.2]
b. 1699
7
Prudence Anderson
[1.1.1.1.1.7.3]
b. Abt 1709
6
James Woodward
[1.1.1.1.1.8]
b. 1623
6
Thomas Woodward
[1.1.1.1.1.9]
c. 6 Feb 1620 d. Aft 1685
6
Benjamin Woodward
[1.1.1.1.1.10]
b. 1626
6
Ezekiel Woodward
[1.1.1.1.1.11]
c. 8 May 1624 d. 29 Jan 1699
3
George Bulstrode Woodward
[1.1.2]
b. 10 Apr 1549 d. 30 Jan 1598
3
Robert Woodward
[1.1.3]
b. 1551
2
Richard Woodward
[1.2]
b. Abt 1540 d. 1596
2
Henry Woodward
[1.3]
b. 1542 bur. 10 Aug 1621
2
William Woodward
[1.4]
b. 1544 d. 1566
2
Katharine Woodward
[1.5]
b. 1546
2
Elizabeth Woodward
[1.6]
b. 1548