Home Page
|
What's New
|
Photos
|
Histories
|
Headstones
|
Reports
|
Surnames
Search
First Name:
Last Name:
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Suomalainen
Svenska
Mary Patrick
1559 -
Submit Photo / Document
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Submit Photo / Doc
Worksheet
Family
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Mary Patrick
[1]
b. 1559
John Wright
b. Abt 1555
2
Elizabeth Wright
[1.1]
b. 1610 d. 26 Dec 1650
William Booth
b. 20 Nov 1608 d. 26 Dec 1657
3
George Booth
[1.1.1]
b. 8 Mar 1631
3
Elizabeth Booth
[1.1.2]
b. 6 Feb 1633 d. 13 Feb 1633
3
Mary Booth
[1.1.3]
b. 26 Mar 1633
+
William Fennet
3
John Booth
[1.1.4]
b. 23 Feb 1634 d. 1719
Mary Lodington
b. 1650 bur. 25 Jun 1740
4
John Booth, Jr
[1.1.4.1]
b. Feb 1673 d. 3 Oct 1723
Elizabeth Lamson
b. Abt 1695
5
John Senior
[1.1.4.1.1]
c. 2 Sep 1717
5
Elizabeth Senior
[1.1.4.1.2]
c. 25 Jul 1719
5
Robert Senior
[1.1.4.1.3]
c. 8 Jun 1722
5
Elizabeth Senior
[1.1.4.1.4]
c. 1 Nov 1723
5
Ann Senior
[1.1.4.1.5]
c. 4 Apr 1725
4
Elizabeth Booth
[1.1.4.2]
b. 1674
4
Marie Booth
[1.1.4.3]
b. 1675 d. 17 Jan 1732
Charles Newcomen
b. 1670 d. 1714
5
Mary Newcomen
[1.1.4.3.1]
b. 17 Nov 1702 d. 30 Apr 1719
5
John Newcomen
[1.1.4.3.2]
b. 1704 d. 8 Feb 1707
5
Charles Newcomen
[1.1.4.3.3]
b. 10 Mar 1706 d. 21 Jul 1767
5
Richard Newcomen
[1.1.4.3.4]
c. 17 Sep 1707 d. 3 Apr 1708
5
Esther Newcomen
[1.1.4.3.5]
c. 17 Sep 1707 d. 16 Apr 1708
5
Nicholas Newcomen
[1.1.4.3.6]
b. 25 Nov 1708 d. 18 Sep 1711
5
John Newcomen
[1.1.4.3.7]
b. 15 Jun 1710 d. 16 Jun 1710
5
Samuel Newcomen
[1.1.4.3.8]
b. 4 Jul 1711
5
Ann Newcomen
[1.1.4.3.9]
b. 4 Oct 1712 d. 13 Sep 1717
5
George Newcomen
[1.1.4.3.10]
b. 25 Feb 1714
4
Anne Booth
[1.1.4.4]
b. 1677 d. 21 Jan 1745
Edward Taylour
b. 1685
5
Amy Taylour
[1.1.4.4.1]
c. 27 Mar 1717
Henry Clulee
b. 1 Jul 1704
6
Edward Cluley
[1.1.4.4.1.1]
c. 8 Jul 1739
6
John Cluley
[1.1.4.4.1.2]
b. 1745 d. 28 Jan 1823
Sarah Hewett
c. 9 Sep 1750 d. 11 Jan 1840
7
Edward Cluley
[1.1.4.4.1.2.1]
b. 28 Apr 1771 d. 9 Dec 1851
Sarah
b. Abt 1773
8
Amy Cluley
[1.1.4.4.1.2.1.1]
b. 9 Mar 1794
8
Henry Cluley
[1.1.4.4.1.2.1.2]
c. 2 Aug 1795
Elizabeth
b. 1778 d. 25 Jul 1840
8
Margery Cluley
[1.1.4.4.1.2.1.3]
b. 1798
8
Jane Cluley
[1.1.4.4.1.2.1.4]
c. 27 Mar 1803 d. 1884
8
John Cluley
[1.1.4.4.1.2.1.5]
c. 17 Jan 1808 d. 13 Jul 1822
8
Richard Cluley
[1.1.4.4.1.2.1.6]
c. 17 Jan 1808
8
Sarah Cluley
[1.1.4.4.1.2.1.7]
c. 8 Apr 1810 bur. 10 Jan 1834
8
Elizabeth Cluley
[1.1.4.4.1.2.1.8]
c. 23 May 1813
7
Elizabeth Cluley
[1.1.4.4.1.2.2]
b. 28 May 1773 bur. 24 May 1833
7
Henry Cluley
[1.1.4.4.1.2.3]
c. 30 Jan 1776 d. 24 May 1833
Sarah Smith
c. 4 Feb 1774 d. 1818
8
John Cluley
[1.1.4.4.1.2.3.1]
b. 5 Mar 1801 d. 6 Mar 1802
8
Joseph Cluley
[1.1.4.4.1.2.3.2]
b. 16 Jun 1803 d. 19 Aug 1807
8
John Cluley
[1.1.4.4.1.2.3.3]
b. 3 Feb 1805 d. 1852
Rhoda Bishop
b. Abt 1805 bur. 3 Mar 1837
9
Thomas Cluley
[1.1.4.4.1.2.3.3.1]
b. Jul 1819 d. 16 Jan 1900
Rebecca Harrison
b. 11 Sep 1823 d. 1905
10
Emma Cluley
[1.1.4.4.1.2.3.3.1.1]
b. 13 Jul 1856 d. Jun 1878
John Mogg
b. 1 Jan 1851 d. 1 Sep 1920
11
Mary Jane Mogg
[1.1.4.4.1.2.3.3.1.1.1]
b. 10 Feb 1875 d. 13 Jul 1949
James Ellsworth Small
b. 28 Sep 1868 d. 26 Nov 1940
12
Harold Small
[1.1.4.4.1.2.3.3.1.1.1.1]
b. 14 May 1893 d. 16 May 1893
12
Frank J Small
[1.1.4.4.1.2.3.3.1.1.1.2]
b. 26 Mar 1894 d. 26 Nov 1953
12
Minnie Bell Small
[1.1.4.4.1.2.3.3.1.1.1.3]
b. 12 Sep 1895 d. 15 Mar 1949
12
Maynard Elias Small
[1.1.4.4.1.2.3.3.1.1.1.4]
b. 22 May 1900 d. 27 Jul 1956
11
Emma Mogg
[1.1.4.4.1.2.3.3.1.1.2]
b. 2 Mar 1878 d. 28 Aug 1948
+
Alfred Currie
b. Abt 1870 d. 18 May 1928
10
Mary Ann Cluley
[1.1.4.4.1.2.3.3.1.2]
b. 25 Apr 1858
10
Thomas Cluley
[1.1.4.4.1.2.3.3.1.3]
b. 23 Oct 1862
Mary Ann Robinson
b. Abt 1861
11
Florence Cluley
[1.1.4.4.1.2.3.3.1.3.1]
b. Abt 1889
11
Mary Ann Cluley
[1.1.4.4.1.2.3.3.1.3.2]
b. 9 Mar 1891
10
Rebecca Cluley
[1.1.4.4.1.2.3.3.1.4]
b. Abt 1865
9
John Cluley
[1.1.4.4.1.2.3.3.2]
b. 14 Jul 1822 d. 30 Sep 1890
Jemima Mann
b. 13 Apr 1817 d. 1903
10
Hannah Cluley
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.1]
b. 1842
10
James Cluley
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.2]
b. 29 Aug 1852 d. 6 Jan 1918
Arrabella Benson
b. 1853
11
John Frederick Cluley
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.2.1]
b. 1873 d. 1876
11
Mary Ann Cluley
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.2.2]
b. 1 Nov 1874 d. 1876
11
Clara Cluley
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.2.3]
b. 25 Dec 1877
11
Edith Clulee
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.2.4]
b. 25 Dec 1879 d. 1880
11
Lily Cluley
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.2.5]
b. 25 Dec 1883
11
Minnie Cluley
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.2.6]
b. 7 Aug 1886 d. 1886
11
Eva Cluley
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.2.7]
b. 4 Mar 1888
11
Ethel Cluley
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.2.8]
b. 6 Oct 1892
+
Waites
b. Abt 1892
11
Bertha Cluley
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.2.9]
b. 1895
+
Charles Smith
b. Abt 1895
10
Clara Cluley
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.3]
b. 29 Aug 1852
David Barford
b. 1852
11
Clara Barford
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.3.1]
b. 1874 d. 1890
11
Florence Maud Barford
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.3.2]
b. 1883 d. 1884
11
Harriet Myrtle Barford
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.3.3]
b. 1887
10
Rhoda Cluley
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.4]
b. 4 Jun 1854 d. 4 May 1885
Henry Hessay
b. 2 Feb 1834
11
Harriet Hessay
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.4.1]
b. 1878
11
Willliam Henry Hessay
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.4.2]
b. 1880 d. 1880
11
John Hessay
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.4.3]
b. 1882
11
George Hessay
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.4.4]
b. 1885 d. 6 Sep 1887
10
Mary Cluley
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.5]
b. 1859
9
Harry Cluley
[1.1.4.4.1.2.3.3.3]
b. 23 May 1824 d. 4 Jun 1825
9
Rebecca Cluley
[1.1.4.4.1.2.3.3.4]
b. 2 Apr 1826 d. 1908
William Smallwood
b. 3 Dec 1828 d. 1866
10
Rhoda Smallwood
[1.1.4.4.1.2.3.3.4.1]
b. 20 Jul 1851 d. Dec 1928
Samuel Hackett
b. 1849 d. 1911
11
Jane Sophia Hackett
[1.1.4.4.1.2.3.3.4.1.1]
c. 10 Jul 1870
11
Samuel Isaac Hackett
[1.1.4.4.1.2.3.3.4.1.2]
c. 13 Apr 1873
11
Annie Rebecca Hackett
[1.1.4.4.1.2.3.3.4.1.3]
b. 1875
Harry Overton
b. Abt 1875
12
Harry Overton
[1.1.4.4.1.2.3.3.4.1.3.1]
b. 1900
11
John William Hackett
[1.1.4.4.1.2.3.3.4.1.4]
c. 10 Oct 1880
11
Martha A Hackett
[1.1.4.4.1.2.3.3.4.1.5]
b. 1880
11
Thomas E Hackett
[1.1.4.4.1.2.3.3.4.1.6]
b. 1883 d. Dec 1934
11
Frances M Hackett
[1.1.4.4.1.2.3.3.4.1.7]
b. Abt 1887
11
Walter Harry Hackett
[1.1.4.4.1.2.3.3.4.1.8]
b. Jul 1889 d. 15 Mar 1944
+
Agnes Tansey
b. 1888
11
Alfred Ernest Hackett
[1.1.4.4.1.2.3.3.4.1.9]
b. 1893
10
Baron Arthur Smallwood
[1.1.4.4.1.2.3.3.4.2]
b. Abt 1852
Jane
b. Abt 1845 d. 1891
11
Louisa Smallwood
[1.1.4.4.1.2.3.3.4.2.1]
b. Abt 1877
Amelia Challis
b. 1853
11
Dorothea Amy Smallwood
[1.1.4.4.1.2.3.3.4.2.2]
b. 1896
11
Baron Alfred Smallwood
[1.1.4.4.1.2.3.3.4.2.3]
b. 1898
10
Fanny Smallwood
[1.1.4.4.1.2.3.3.4.3]
b. 15 Feb 1854 d. 1904
+
John Tallis
b. 1851
10
Catherine Smallwood
[1.1.4.4.1.2.3.3.4.4]
b. 15 Feb 1857 d. Jul 1886
John Warden
b. 23 Jan 1853 d. Bef 1891
11
Ellen Warden
[1.1.4.4.1.2.3.3.4.4.1]
b. Dec 1877 d. 1922
Arthur Robottom
b. Mar 1873
12
Arthur Robottom
[1.1.4.4.1.2.3.3.4.4.1.1]
b. 1899 d. 1964
12
Ellen Robottom
[1.1.4.4.1.2.3.3.4.4.1.2]
b. 1901
12
Albert Robottom
[1.1.4.4.1.2.3.3.4.4.1.3]
b. Jan 1904 d. Jul 1967
11
Cathrine Warden
[1.1.4.4.1.2.3.3.4.4.2]
b. Abt 1879
+
Nathaniel Pollard
11
Lily Warden
[1.1.4.4.1.2.3.3.4.4.3]
b. Abt 1883
11
Violet Adelaide Warden
[1.1.4.4.1.2.3.3.4.4.4]
b. 20 Dec 1884 d. 1975
George Henry Grimley
b. 2 Mar 1881 d. 8 Jan 1965
12
John Grimley
[1.1.4.4.1.2.3.3.4.4.4.1]
b. Abt 1904
12
Edna Grimley
[1.1.4.4.1.2.3.3.4.4.4.2]
b. 1908 d. 22 Feb 1980
12
Phyllis Grimley
[1.1.4.4.1.2.3.3.4.4.4.3]
b. 1912 d. 2001
12
George Grimley
[1.1.4.4.1.2.3.3.4.4.4.4]
b. 1920 d. 2004
12
Rose Grimley
[1.1.4.4.1.2.3.3.4.4.4.5]
b. 1921 d. 2 May 1956
12
Joseph Grimley
[1.1.4.4.1.2.3.3.4.4.4.6]
b. 3 Dec 1922 d. 8 Mar 2002
12
Ronald Peter Grimley
[1.1.4.4.1.2.3.3.4.4.4.7]
b. Abt 1923 d. 1996
10
William Smallwood
[1.1.4.4.1.2.3.3.4.5]
b. 14 Oct 1861
+
Mary Wooliscroft
b. 1859
10
Mary Ann Smallwood
[1.1.4.4.1.2.3.3.4.6]
c. 22 Sep 1867
10
Martha Louisa Smallwood
[1.1.4.4.1.2.3.3.4.7]
c. 24 Sep 1871 d. Dec 1961
George Henry Cranmer
b. Jul 1869 d. 18 Jul 1940
11
George Reginalds Cranmer
[1.1.4.4.1.2.3.3.4.7.1]
b. 26 Dec 1897 d. Jun 1981
+
Amy Edith Adams
b. 5 Apr 1901 d. Oct 1985
9
Mary Cluley
[1.1.4.4.1.2.3.3.5]
b. 27 Jan 1828 d. 1893
+
Charles Ainsworth
b. 1832
9
Martha Cluley
[1.1.4.4.1.2.3.3.6]
b. 17 Oct 1830
8
Henry Cluley
[1.1.4.4.1.2.3.4]
c. 18 Jan 1807 d. 19 Aug 1840
Catherine Threlfall
b. 1805 d. 1919
9
John Cluley
[1.1.4.4.1.2.3.4.1]
b. 17 Jul 1829 bur. 8 Mar 1830
9
Sarah Priscilla Cluley
[1.1.4.4.1.2.3.4.2]
b. 13 Feb 1831 d. 13 Apr 1865
Joseph Greaves
b. 22 Feb 1832 d. 19 Jun 1904
10
John Cluley Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.1]
b. 21 Dec 1854 d. 8 Oct 1933
Althea Card
b. 6 Dec 1860 d. 28 Jan 1944
11
John Card Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.1.1]
b. 29 Aug 1877 d. 15 Apr 1955
Gracie Davis
b. 30 Jul 1880 d. 25 Nov 1916
12
Althea Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.1.1.1]
b. 11 Jul 1901 d. 6 Dec 1906
12
John Ray Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.1.1.2]
b. 19 Jun 1903 d. 5 May 1946 [
=>
]
12
Auline Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.1.1.3]
b. 23 Feb 1906 d. 27 Sep 1906
12
Alvin Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.1.1.4]
b. 25 Feb 1906 d. 12 Oct 1906
12
Phyllis Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.1.1.5]
b. 4 Sep 1908 d. 20 Feb 1998
12
Vera Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.1.1.6]
b. 12 Jul 1910 d. 26 Jun 1980 [
=>
]
12
Vella Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.1.1.7]
b. 12 Jul 1910 d. 6 Feb 1984
Mary Jane Pendleton
b. 6 May 1888 d. 10 Feb 1968
12
Clarice Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.1.1.8]
b. 21 May 1917 d. 11 Aug 2002
12
Howard Pershing Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.1.1.9]
b. 13 Sep 1918 d. 16 Apr 1993
11
Hattie Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.1.2]
b. 15 Sep 1879 d. 11 Mar 1943
Lewis Sumner Pond
b. 9 Nov 1880 d. 23 Feb 1948
12
Julia Pond
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.1.2.1]
b. 20 Sep 1904 d. Nov 1992
12
LaVerna Pond
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.1.2.2]
b. 22 Feb 1906 d. 13 Jan 1980
12
Keith Greaves Pond
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.1.2.3]
b. 27 Jul 1908 d. 15 Mar 1984
12
Althea Pond
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.1.2.4]
b. 4 Dec 1910 d. 27 Jun 2006 [
=>
]
12
Chase Greaves Pond
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.1.2.5]
b. 15 Jan 1914 d. 31 Jan 1996
11
Cyrus LeRoy Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.1.3]
b. 19 Sep 1882 d. 21 Dec 1951
Leona Geddes
b. 7 Dec 1881 d. 26 Sep 1963
12
Cyrus William Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.1.3.1]
b. 20 Mar 1908 d. 27 Jan 2000 [
=>
]
12
Ora Geddes Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.1.3.2]
b. 9 Sep 1909 d. 16 Mar 1998 [
=>
]
12
Paul Card Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.1.3.3]
b. 11 Feb 1913 d. 4 Feb 1998
12
Reed Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.1.3.4]
b. 22 Apr 1916 d. 4 Jul 1925
12
Helen Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.1.3.5]
b. 7 Apr 1918 d. 7 Jun 2010
12
Stewart Geddes Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.1.3.6]
b. 29 Aug 1920 d. 4 Apr 2004
11
Edwin Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.1.4]
b. 23 Nov 1884 d. 27 Nov 1884
11
Myrtle Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.1.5]
b. 27 Oct 1886 d. 26 Feb 1953
Ira Leonidas Neeley
b. 23 Jan 1884 d. 18 Oct 1951
12
Letha Neeley
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.1.5.1]
b. 29 Sep 1907 d. 9 Jan 1991 [
=>
]
12
Inez Neeley
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.1.5.2]
b. 19 Jun 1909 d. 16 Sep 1931 [
=>
]
12
Ariel Greaves Neeley
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.1.5.3]
b. 6 Jun 1913 d. 24 Jan 2004
12
Lorna Neeley
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.1.5.4]
b. 1 Oct 1918 d. 8 Jul 1994
12
Roma Neeley
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.1.5.5]
b. 1 Jul 1921 d. 28 Jan 2015
11
Harley Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.1.6]
b. 13 Jul 1889 d. 16 Aug 1976
Mabel Carpenter
b. 28 Oct 1891 d. 25 Oct 1947
12
Keith Carpenter Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.1.6.1]
b. 16 Dec 1918 d. 9 Oct 2008
12
Harley Carpenter Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.1.6.2]
b. 20 Oct 1922 d. 15 Oct 2000
+
Ellen Mabel Bell
b. 9 Mar 1908 d. 21 Jul 1997
11
Card Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.1.7]
b. 2 Feb 1894 d. 12 Feb 1977
+
Elsie Callysta Egbert
b. 12 Dec 1892 d. 24 Aug 1962
+
Veir Christensen
b. 8 Jun 1896 d. 8 Apr 1978
10
Elizabeth Cluley Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.2]
b. 21 Oct 1856 d. 5 May 1942
David Cullen Eames
b. 1 Sep 1851 d. 9 Feb 1929
11
Edward Eames
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.1]
b. 21 Aug 1878 d. 21 Aug 1878
11
David Greaves Eames
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.2]
b. 29 Sep 1879 d. 27 Jan 1961
Pearl Lorena Geddes
b. 22 Feb 1883 d. 5 Aug 1967
12
David Ivo Eames
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.2.1]
b. 25 Apr 1906 d. 28 Aug 1988 [
=>
]
12
Melba Geddes Eames
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.2.2]
b. 4 May 1909 d. 27 Mar 1996 [
=>
]
12
Waldo Geddes Eames
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.2.3]
b. 11 Apr 1911 d. 1 Nov 1996
12
Roberta Geddes Eames
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.2.4]
b. 25 Apr 1913 d. 3 Jul 1980
12
Venice Geddes Eames
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.2.5]
b. 23 Apr 1915 d. 2 May 1996 [
=>
]
12
Wendell Geddes Eames
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.2.6]
b. 30 May 1917 d. 10 Mar 2001
12
Ruby Geddes Eames
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.2.7]
b. 19 Jul 1919 d. 21 Sep 1991
12
Dora Dean Eames
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.2.8]
b. 6 Mar 1924 d. 14 Nov 2015 [
=>
]
12
Garth Geddes Eames
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.2.9]
b. 10 May 1927 d. 13 Sep 2011 [
=>
]
11
Sarah Greaves Eames
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.3]
b. 1 Nov 1881 d. 27 Nov 1970
Arthur Tippets
b. 20 Jun 1881 d. 2 Jun 1960
12
Harold Ray Tippets
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.3.1]
b. 27 Nov 1905 d. 22 Mar 1908
12
Ellen Elean Tippets
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.3.2]
b. 22 Mar 1907 d. 6 Aug 1987
12
Authur Merlin Tippets
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.3.3]
b. 4 Feb 1909 d. 24 Dec 1983 [
=>
]
12
Thero Eames "Tip" Tippets
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.3.4]
b. 25 Apr 1911 d. 6 Dec 1980 [
=>
]
12
Vaughan Eames Tippets
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.3.5]
b. 9 Feb 1913 d. 5 Mar 2007
12
David Scott Tippets
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.3.6]
b. 25 Jan 1918 d. 25 Jan 1918
12
James Howard Tippets
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.3.7]
b. 30 Jun 1922 d. 2 Jan 1998
11
Elizabeth Greaves "Lillie" Eames
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.4]
b. 6 Jun 1884 d. 28 Dec 1966
Frank Taft Benson
b. 23 Apr 1883 d. 19 Feb 1923
12
Gladys Benson
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.4.1]
b. 12 Nov 1909 d. 27 Jan 1995 [
=>
]
12
Carmen Benson
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.4.2]
b. 4 Nov 1911 d. 17 Aug 2001 [
=>
]
12
Harold Eames Benson
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.4.3]
b. 4 Nov 1911 d. 20 Jul 1948 [
=>
]
12
Flora Benson
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.4.4]
b. 30 Jan 1916 d. 14 Oct 1984 [
=>
]
12
Zenda Benson
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.4.5]
b. 25 Oct 1918 d. 27 Feb 2003 [
=>
]
12
Frank Eames Benson
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.4.6]
b. 26 Sep 1920 d. 2 Jan 1923
12
Nellie Louisa Benson
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.4.7]
b. 11 Sep 1923 d. 11 Oct 1975 [
=>
]
11
Rebecca May Eames
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.5]
b. 28 Dec 1886 d. 25 Jul 1955
Dr. Thomas Ray Gledhill
b. 13 Feb 1883 d. 18 Feb 1955
12
Ora Mae Gledhill
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.5.1]
b. 17 Jun 1908 d. 15 Jan 1988
12
Preston Ray Gledhill
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.5.2]
b. 19 Mar 1915 d. 13 May 2003 [
=>
]
12
Utahna Gledhill
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.5.3]
b. 10 Aug 1917 d. 22 Apr 2009
12
Evelyn Gledhill
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.5.4]
b. 26 Aug 1919 d. 8 Oct 1997 [
=>
]
12
David Eames Gledhill
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.5.5]
b. 17 Aug 1921 d. 27 Nov 1965
12
Ilah Dean Gledhill
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.5.6]
b. 29 Oct 1923 d. 13 Aug 2000
11
Aerial Guy Eames
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.6]
b. 18 Jul 1889 d. 27 Jan 1971
Flora Edna Geddes
b. 20 Sep 1889 d. 16 Feb 1985
12
Donna Geddes Eames
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.6.1]
b. 24 Jul 1915 d. 4 Feb 2011 [
=>
]
12
Veda Geddes Eames
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.6.2]
b. 10 Jun 1917 d. 1 Nov 1990 [
=>
]
12
Edna Geddes Eames
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.6.3]
b. 21 Oct 1918 d. 19 Mar 2011 [
=>
]
12
Nathaniel Howard Eames
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.6.4]
b. 30 Sep 1921 d. 14 Jan 2010 [
=>
]
12
Aerial Guy Eames, Jr
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.6.5]
b. 20 Apr 1924 d. 21 Dec 2015
12
George Albert Eames
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.6.6]
b. 9 Dec 1927 d. 19 May 1994 [
=>
]
11
Nathaniel Howard Eames
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.7]
b. 3 Aug 1892 d. 27 Jan 1921
Ruby Neagle
b. 30 Jun 1890 d. 12 Jan 1957
12
Nathaniel Howard Eames
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.7.1]
b. 14 Dec 1920 d. 4 May 1921
11
Joseph Leland Eames
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.8]
b. 23 Jun 1895 d. 12 Feb 1970
Cyrena Cantwell Kennington
b. 23 Jan 1902 d. 12 May 1983
12
Ermon Eames
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.8.1]
b. 13 Jun 1922 d. 26 Feb 2015
12
Joseph Leland Eames, Jr
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.8.2]
b. 26 Jan 1924 d. 12 May 1981
11
Rowland Eames
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.9]
b. 14 May 1898 d. 16 May 1898
11
Ilah Eames
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.10]
b. 8 Jun 1902 d. 17 May 1994
Kenneth Mosher Carpenter
b. 7 Feb 1902 d. 1 Aug 1990
12
Living
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.10.1]
10
Joseph Cluley Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.3]
b. 1 Dec 1858 d. 16 Nov 1884
Catherine Mary Eames
b. 20 Sep 1855 d. 31 May 1931
11
Joseph Eames Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.3.1]
b. 2 Nov 1880 d. 6 Jun 1954
Pernecy Jane Dudley
b. 16 Apr 1882 d. 9 May 1918
12
Joseph Dudley Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.3.1.1]
b. 18 May 1908 d. 16 Apr 1953
12
Florence Dudley Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.3.1.2]
b. 2 Jul 1909 d. 10 Jul 1955
12
Pernecy Dudley Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.3.1.3]
b. 26 Jan 1913 d. 24 Aug 1993 [
=>
]
12
Vera Dudley Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.3.1.4]
b. 29 Nov 1914 d. 22 Mar 1991
12
Mary Oretta Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.3.1.5]
b. 20 May 1917 d. 27 Feb 1993
Ethelyn May Olivier
b. 18 Dec 1896 d. 16 Jul 1955
12
Marguerite Oliver Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.3.1.6]
b. 21 Feb 1922 d. 11 Feb 2004
12
Thelma May Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.3.1.7]
b. 25 Sep 1925 d. 12 Mar 1980
12
Joseph Oliver Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.3.1.8]
b. 22 Dec 1929 d. 15 Aug 2002
11
Olive Eames Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.3.2]
b. 6 May 1883 d. Apr 1884
11
Oliver Eames Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.3.3]
b. 6 May 1883 d. 13 Oct 1971
Caroline Louise Petersen
b. 16 Dec 1893 d. 23 Feb 1983
12
Oliver Wendell Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.3.3.1]
b. 14 Jun 1917 d. 17 Oct 1986
12
Olive Louise Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.3.3.2]
b. 22 Oct 1918 d. 25 Aug 2017
12
Nathan Dale Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.3.3.3]
b. 23 Aug 1920 d. 26 Apr 1993
12
Fay Maurine Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.3.3.4]
b. 30 Oct 1922 d. 5 Feb 1928
12
Dorothy Dean Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.3.3.5]
b. 4 Jun 1926 d. 28 Aug 2021
10
Thomas Cluley Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.4]
b. 2 Nov 1860 d. 5 May 1920
Hannah Kidd
b. 22 Mar 1864 d. 29 Nov 1910
11
Ethel Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.4.1]
b. 11 May 1888 d. 12 Oct 1975
Ervin John Kunz
b. 20 Sep 1889 d. 7 Oct 1946
12
Earl Greaves Kunz
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.4.1.1]
b. 23 Jan 1913 d. 5 Nov 1996
12
Weldon Ervin Kunz
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.4.1.2]
b. 11 Apr 1916 d. 7 Mar 1917
12
Norma Ethel Kunz
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.4.1.3]
b. 6 Jun 1918 d. 2 Mar 2016
11
Thomas Kidd Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.4.2]
b. 1 Jan 1890 d. 4 Feb 1973
Harriet Johnson
b. 14 Aug 1897 d. 1 Dec 1982
12
Melvin J Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.4.2.1]
b. 20 Oct 1917 d. 13 Feb 1999 [
=>
]
11
Levean Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.4.3]
b. 20 Apr 1892 d. 17 Jan 1962
11
Cluely Kidd Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.4.4]
b. 19 Oct 1894 d. 6 May 1978
Maree Hollingsworth
b. 3 Jan 1899 d. 19 Oct 1931
12
Karma H Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.4.4.1]
b. 2 Feb 1921 d. 30 Jun 1998
12
Lou Jean Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.4.4.2]
b. 12 Dec 1924 d. 2 Sep 1961
+
Gayle Fisher
b. 19 Oct 1911 d. 21 Mar 1995
11
Daughter Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.4.5]
b. 2 Mar 1897
11
Seymour Kidd Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.4.6]
b. 29 Jul 1903 d. 3 Feb 1990
Vera Orena Wixom
b. 3 Apr 1905 d. 9 Apr 1971
12
Jerald Wixom Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.4.6.1]
b. 13 May 1926 d. 17 Mar 2017
12
Alan Wixom Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.4.6.2]
b. 30 Nov 1927 d. 23 Apr 2014
12
Donna Gaye Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.4.6.3]
b. 29 May 1934 d. 16 May 1984 [
=>
]
11
Thelma Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.4.7]
b. 11 May 1906 d. 22 Jan 1908
11
Aleda Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.4.8]
b. 8 Apr 1908 d. 20 Jul 1908
11
Donald Kidd Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.4.9]
b. 20 Jan 1910 d. 18 Aug 1996
+
Idana Swainston
b. 22 Jan 1913 d. 14 Aug 1981
+
Norene R Sears
b. 3 Apr 1910 d. 8 Mar 2002
Alice Sina Jensen
b. 16 Apr 1876 d. 22 Mar 1963
11
Vaughn Jensen Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.4.10]
b. 20 Dec 1913 d. 22 Jan 2008
Marian Berrett
b. 19 Feb 1917 d. 6 Dec 1982
12
Son Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.4.10.1]
b. 7 May 1940 d. 7 May 1940
12
Suzanne Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.4.10.2]
b. 28 Jul 1941 d. 19 Apr 2001
+
O'Enone Callan
b. 25 Nov 1914 d. 11 Oct 1991
11
Leo Jensen Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.4.11]
b. 21 Mar 1916 d. 6 Jun 1988
Verba Irene Larsen
b. 18 Oct 1915 d. 2 Jul 1968
12
James Ralph Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.4.11.1]
b. 16 Nov 1951 d. 26 Jan 2011
+
Amelia Alice Douglas
b. 15 Apr 1916 d. 4 Dec 2008
11
Elsie Jensen Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.4.12]
b. 6 Nov 1919 d. 31 Mar 1996
+
Lloyd Sylvester Checketts
b. 30 Jun 1918 d. 5 May 2008
10
Priscilla Cluley Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.5]
b. 17 Mar 1863 d. 24 Feb 1917
Thomas Nelson Rowland
b. 12 Mar 1860 d. 6 Mar 1910
11
Thomas Greaves Rowland
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.5.1]
b. 17 Feb 1886 d. 7 May 1953
Zina Violet John Hawkley
b. 4 Aug 1888 d. 16 Sep 1966
12
Daughter Rowland
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.5.1.1]
b. Nov 1911
12
Zina Rowland
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.5.1.2]
b. 16 Nov 1912 d. 16 Nov 1912
12
Thomas Hawkley Rowland
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.5.1.3]
b. 29 Jan 1914 d. 6 Oct 1985
12
Joseph Brigham Rowland
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.5.1.4]
b. 9 Oct 1915 d. 24 Jan 2002
12
Helen Rowland
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.5.1.5]
b. 22 Aug 1917 d. 7 Apr 2007 [
=>
]
12
Leonora Rowland
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.5.1.6]
b. 28 Aug 1919 d. Dec 2006
12
Edith Rowland
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.5.1.7]
b. 11 May 1921 d. 10 Nov 2017
12
Edwin Ross Rowland
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.5.1.8]
b. 18 Aug 1923 d. 9 May 2016
11
Edward Greaves Rowland
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.5.2]
b. 28 Aug 1889 d. 28 Aug 1889
11
Leon Greaves Rowland
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.5.3]
b. 12 Oct 1890 d. 28 Sep 1891
11
Lenora Rowland
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.5.4]
b. 26 Oct 1894 d. 13 Apr 1912
11
Sarah Priscilla Rowland
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.5.5]
b. 29 Oct 1898 d. 1 Dec 1979
10
Mary Ann Cluley Greaves
[1.1.4.4.1.2.3.4.2.6]
b. 2 Apr 1865 d. 8 Apr 1865
9
Ann Cluley
[1.1.4.4.1.2.3.4.3]
c. 2 Jan 1828 bur. 26 Nov 1828
9
Joseph Cluley
[1.1.4.4.1.2.3.4.4]
c. 28 Jun 1835 bur. 21 Feb 1836
9
Elizabeth Cluley
[1.1.4.4.1.2.3.4.5]
c. 13 Feb 1837 bur. 5 Mar 1837
9
Henry Cluley
[1.1.4.4.1.2.3.4.6]
c. 6 May 1838 d. 24 Feb 1839
7
John Cluley
[1.1.4.4.1.2.4]
b. 15 Mar 1778 d. 11 May 1852
Mary Hughes
b. Abt 1778 d. 29 Sep 1813
8
William Cluley
[1.1.4.4.1.2.4.1]
b. 27 Jun 1798
8
Ann Cluley
[1.1.4.4.1.2.4.2]
b. 14 Sep 1800
8
John Cluley
[1.1.4.4.1.2.4.3]
b. 7 Dec 1802
8
Sarah Cluley
[1.1.4.4.1.2.4.4]
b. 24 Feb 1805
8
Elizabeth Cluley
[1.1.4.4.1.2.4.5]
b. 15 Dec 1807
8
Mary Cluley
[1.1.4.4.1.2.4.6]
b. 3 Jan 1813 bur. 26 Apr 1813
8
Jane Cluley
[1.1.4.4.1.2.4.7]
c. 27 Mar 1803 d. 1884
7
Mary Cluley
[1.1.4.4.1.2.5]
b. 13 Jan 1781
7
Sarah Cluley
[1.1.4.4.1.2.6]
b. 13 Jan 1781
7
Richard Cluley
[1.1.4.4.1.2.7]
b. 30 Nov 1783 d. 3 Sep 1834
+
Martha Lapworth
b. 29 Aug 1788
7
William Cluley
[1.1.4.4.1.2.8]
b. 30 Jul 1786 d. 6 Feb 1872
Anne Thorpe Geydon
b. 11 Jan 1803
8
William Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.1]
b. 2 Apr 1826 d. 28 Sep 1856
8
Abraham Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.2]
b. 4 Feb 1828 d. 28 Apr 1874
Sarah Morris
b. 24 Aug 1835 d. 24 Mar 1869
9
William Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.2.1]
b. 12 Feb 1860
9
Louisa Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.2.2]
b. 18 Sep 1861 d. 30 May 1920
Edward Thomas Handley, Jr
b. 16 May 1839 d. 6 Oct 1906
10
Alice Handley
[1.1.4.4.1.2.8.2.2.1]
b. 1895 d. 1895
10
Vera May Handley
[1.1.4.4.1.2.8.2.2.2]
b. 13 Sep 1896 d. 5 Jul 1967
Patrick Charles Paul Heaphy
b. 20 May 1885 d. 7 Feb 1952
11
Eric Edward Thomas Heaphy
[1.1.4.4.1.2.8.2.2.2.1]
b. 19 Jan 1920 d. 7 Jun 1984
11
Gerald Charles Heaphy
[1.1.4.4.1.2.8.2.2.2.2]
b. 6 Jul 1921 d. 19 Dec 1921
11
Maurice Patrick Heaphy
[1.1.4.4.1.2.8.2.2.2.3]
b. 3 Jun 1922 d. 2 Jun 1985
Catherine Patricia Fox
b. 1922 d. 5 Sep 2006
12
Michael Evan Heaphy
[1.1.4.4.1.2.8.2.2.2.3.1]
b. 5 Aug 1952 d. 14 Jan 2007
11
Brian Aubrey Trevor Heaphy
[1.1.4.4.1.2.8.2.2.2.4]
b. 12 Oct 1923 d. 6 Jun 1999
11
Pauline Mary Heaphy
[1.1.4.4.1.2.8.2.2.2.5]
b. 21 Feb 1926 d. 4 Feb 1961
+
Sydney Leonard Stock
b. 1917 d. 1994
11
Betty Grace Heaphy
[1.1.4.4.1.2.8.2.2.2.6]
b. 13 Mar 1931 d. 20 Mar 1985
+
Raymond Samuel Ward
b. 1924 d. 3 Jan 1998
11
Val Heaphy
[1.1.4.4.1.2.8.2.2.2.7]
+
Wood
11
Beryl Heaphy
[1.1.4.4.1.2.8.2.2.2.8]
11
John Heaphy
[1.1.4.4.1.2.8.2.2.2.9]
11
Jessie Heaphy
[1.1.4.4.1.2.8.2.2.2.10]
10
Grace Handley
[1.1.4.4.1.2.8.2.2.3]
b. 16 Oct 1898 d. 28 Jan 1975
Edward Orlando Terry Tuck
b. 22 May 1893 d. 6 Oct 1958
11
Cushla Louise Terry Tuck
[1.1.4.4.1.2.8.2.2.3.1]
b. 24 Dec 1925 d. 1 May 2003
Douglas Alan Jamieson
b. 5 May 1931 d. Feb 2003
12
Living
[1.1.4.4.1.2.8.2.2.3.1.1]
12
Living
[1.1.4.4.1.2.8.2.2.3.1.2]
[
=>
]
12
Living
[1.1.4.4.1.2.8.2.2.3.1.3]
11
Colleen Mary Terry Tuck
[1.1.4.4.1.2.8.2.2.3.2]
b. 25 Feb 1927 d. 11 Dec 1995
Living
12
Living
[1.1.4.4.1.2.8.2.2.3.2.1]
12
Living
[1.1.4.4.1.2.8.2.2.3.2.2]
[
=>
]
11
Living
[1.1.4.4.1.2.8.2.2.3.3]
Living
12
Living
[1.1.4.4.1.2.8.2.2.3.3.1]
[
=>
]
12
Living
[1.1.4.4.1.2.8.2.2.3.3.2]
[
=>
]
12
Living
[1.1.4.4.1.2.8.2.2.3.3.3]
12
Living
[1.1.4.4.1.2.8.2.2.3.3.4]
12
Living
[1.1.4.4.1.2.8.2.2.3.3.5]
11
Living
[1.1.4.4.1.2.8.2.2.3.4]
Living
12
Living
[1.1.4.4.1.2.8.2.2.3.4.1]
[
=>
]
12
Living
[1.1.4.4.1.2.8.2.2.3.4.2]
[
=>
]
12
Living
[1.1.4.4.1.2.8.2.2.3.4.3]
[
=>
]
12
Living
[1.1.4.4.1.2.8.2.2.3.4.4]
10
Elsie Handley
[1.1.4.4.1.2.8.2.2.4]
b. 16 Oct 1898 d. 16 Oct 1898
9
Annie Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.2.3]
b. 24 Aug 1863 d. 17 Jun 1922
8
Harry Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.3]
b. 9 May 1830
Ann Brookes
b. Abt 1829
9
Alice Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.3.1]
b. 17 Oct 1864
John Baker
b. 1863 d. 1937
10
Alice Gertrude Baker
[1.1.4.4.1.2.8.3.1.1]
b. 1885
10
John Horace Baker
[1.1.4.4.1.2.8.3.1.2]
b. 9 Jun 1887 d. 20 Oct 1961
Elizabeth James
b. 21 Feb 1887 d. 21 Apr 1961
11
Horace Joseph Thomas Baker
[1.1.4.4.1.2.8.3.1.2.1]
b. 30 Sep 1914 d. 23 Aug 1978
Louisa Radford
b. 4 Dec 1916 d. 13 Jan 2001
12
Living
[1.1.4.4.1.2.8.3.1.2.1.1]
[
=>
]
12
Living
[1.1.4.4.1.2.8.3.1.2.1.2]
10
Edith Baker
[1.1.4.4.1.2.8.3.1.3]
b. Abt 1891
10
Dorothy Baker
[1.1.4.4.1.2.8.3.1.4]
b. Abt 1892 d. Abt 1910
10
Arthur Baker
[1.1.4.4.1.2.8.3.1.5]
b. Abt 1899
Maud
b. Abt 1900
11
Living
[1.1.4.4.1.2.8.3.1.5.1]
10
Harry Baker
[1.1.4.4.1.2.8.3.1.6]
b. Abt 1900
10
Florence Baker
[1.1.4.4.1.2.8.3.1.7]
b. Abt 1900
Len Parkes
b. Abt 1900
11
Living
[1.1.4.4.1.2.8.3.1.7.1]
9
Arthur Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.3.2]
b. Abt 1868
9
Fanny Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.3.3]
b. Abt 1872
9
Harry Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.3.4]
b. Abt 1875
Florence Amelia McCann
b. 1874
10
Arthur Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.3.4.1]
b. 1903
10
Florence Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.3.4.2]
b. 1906
10
Walter Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.3.4.3]
b. 1910
+
Nellie Camel
b. 1910
8
Richard Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.4]
b. 1 Jul 1832
Elizabeth Sedgwick
b. Abt 1833
9
Edward Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.4.1]
b. 1865
9
Alfred Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.4.2]
b. 1868 d. 1941
Ellen Elizabeth Wright
b. 1873
10
Wilfred Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.4.2.1]
b. 1895
10
Leonard Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.4.2.2]
b. 1898
10
Dorothy Elizabeth Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.4.2.3]
b. 1911
9
Arthur Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.4.3]
b. 20 Mar 1873
Mary Eliza Duffield
b. 1870
10
Arthur Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.4.3.1]
b. 1894
10
Minnie Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.4.3.2]
b. 1896
10
Elsie Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.4.3.3]
b. 1898
10
William Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.4.3.4]
b. 1899
Ruth Doody
b. 1900
11
Living
[1.1.4.4.1.2.8.4.3.4.1]
Living
12
Living
[1.1.4.4.1.2.8.4.3.4.1.1]
12
Living
[1.1.4.4.1.2.8.4.3.4.1.2]
[
=>
]
12
Living
[1.1.4.4.1.2.8.4.3.4.1.3]
12
Living
[1.1.4.4.1.2.8.4.3.4.1.4]
10
Mary Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.4.3.5]
b. 1900
10
Beatrice Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.4.3.6]
b. 13 Aug 1902
Ernest Robert James
b. 1900
11
Beatrice Mary James
[1.1.4.4.1.2.8.4.3.6.1]
b. 1924 d. 1 May 1955
8
Edward Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.5]
b. 20 Jul 1834
Rachel Makin
b. 14 Dec 1833
9
William Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.5.1]
b. 1860
Mary Hannah Merchant
b. 1865
10
Alice Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.5.1.1]
b. 1883
10
Albert Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.5.1.2]
b. 1884
10
George H Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.5.1.3]
b. 1885
10
Lizzie Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.5.1.4]
b. 1888
10
Ethel Florence Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.5.1.5]
b. 1892
10
Edith Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.5.1.6]
b. 1898
10
Harold Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.5.1.7]
b. 1901
9
Annie Elizabeth Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.5.2]
b. 1861
9
Edward Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.5.3]
b. 1863
9
George Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.5.4]
b. 1865
9
Gertrude Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.5.5]
b. 1868
9
Thomas Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.5.6]
b. 1870 d. 1945
Elizabeth Maxfield
b. Abt 1869
10
Edward Samuel Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.5.6.1]
b. Abt 1890
10
Beatrice Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.5.6.2]
b. Abt 1895
10
Harold Henry Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.5.6.3]
b. Abt 1901
Rose Swan
b. 1905
11
Living
[1.1.4.4.1.2.8.5.6.3.1]
Living
12
Living
[1.1.4.4.1.2.8.5.6.3.1.1]
[
=>
]
9
Alice Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.5.7]
b. 1871
9
Eleanor Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.5.8]
b. 1873
9
Kate Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.5.9]
b. 1877
8
Thomas Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.6]
b. 26 Mar 1837 d. 1892
Emma Loffill
b. 15 Apr 1832 d. Oct 1905
9
Annie Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.6.1]
b. 1861
9
Emma J Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.6.2]
b. 1864
9
Thomas Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.6.3]
b. 1868
Elizabeth
b. Abt 1876
10
Thomas William Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.6.3.1]
b. 1900
9
Elizabeth Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.6.4]
b. 1872
9
Harry Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.6.5]
b. 1874
8
George Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.7]
b. 15 Nov 1840 d. 2 May 1907
Emma Taylor
b. Abt 1841
9
Ann Emma Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.7.1]
b. 20 Feb 1861 d. 1861
9
Emma Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.7.2]
b. Apr 1867 d. Jan 1895
9
Elizabeth Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.7.3]
b. 1869 d. 1913
8
Parker Thorpe Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.8]
b. 29 Aug 1843 d. 6 Jan 1853
8
Robert Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.9]
b. 5 Sep 1845
Emily Churchill
b. 1841 d. Jun 1871
9
Ann Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.9.1]
b. 1867
+
George Henry Palmer
b. Abt 1866
9
William George Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.9.2]
b. 1869
Fanny Singer
b. 1869
10
Arthur Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.9.2.1]
b. 1893
10
Albert Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.9.2.2]
b. 1895
10
Gilbert Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.9.2.3]
b. 1897
10
George Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.9.2.4]
b. 1900
10
Winifred Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.9.2.5]
b. 1902
10
Victor Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.9.2.6]
b. 1906
Elsie Bourne
b. 1904
11
Living
[1.1.4.4.1.2.8.9.2.6.1]
Living
12
Living
[1.1.4.4.1.2.8.9.2.6.1.1]
12
Living
[1.1.4.4.1.2.8.9.2.6.1.2]
10
Dorothy Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.9.2.7]
b. 1908
10
Ethel Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.9.2.8]
b. 1911
Ellen Stevens
b. 1837
9
Minnie Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.9.3]
b. 1874
9
Sarah Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.9.4]
b. 1876
9
Ellen Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.9.5]
b. 1878
9
Emma Cluley
[1.1.4.4.1.2.8.9.6]
b. 1881
7
Ann Cluley
[1.1.4.4.1.2.9]
b. 20 May 1793 d. Abt 1831
William Holdham
b. Abt 1793
8
Samuel Holdham
[1.1.4.4.1.2.9.1]
b. Feb 1819
8
John Holdham
[1.1.4.4.1.2.9.2]
b. Apr 1821 d. 17 Mar 1822
8
William Holdham
[1.1.4.4.1.2.9.3]
b. 22 Oct 1826
8
Charles Holdham
[1.1.4.4.1.2.9.4]
b. 22 Oct 1826
8
Mary Holdham
[1.1.4.4.1.2.9.5]
b. Apr 1830
4
William Booth
[1.1.4.5]
b. 1678 d. 18 Oct 1707
4
Thomas Booth
[1.1.4.6]
b. 1680
Anne Penyston
b. 1638 d. May 1668
4
Mary Booth
[1.1.4.7]
b. 1662
4
Anne Booth
[1.1.4.8]
b. 1663
4
Martha Booth
[1.1.4.9]
c. 3 Nov 1665 d. 24 Apr 1722
3
William Booth
[1.1.5]
b. 17 Jul 1636 d. 28 Nov 1652
3
Thomas Booth
[1.1.6]
b. 3 Oct 1637
+
Elizabeth Middlemore
b. 1641
3
Edmund Booth
[1.1.7]
b. 12 Nov 1637
3
Marmaduke Booth
[1.1.8]
b. 23 May 1639 d. 2 Mar 1640
3
Anne Booth
[1.1.9]
b. 9 Aug 1640 d. 11 Aug 1640