Home Page
|
What's New
|
Photos
|
Histories
|
Headstones
|
Reports
|
Surnames
Search
First Name:
Last Name:
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Suomalainen
Svenska
Edward Wright
1519 -
Submit Photo / Document
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Submit Photo / Doc
Worksheet
Family
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Edward Wright
[1]
b. 1519
Jennet Carter
b. 1523
2
John Wright
[1.1]
b. Abt 1555
Mary Patrick
b. 1559
3
Elizabeth Wright
[1.1.1]
b. 1610 d. 26 Dec 1650
William Booth
b. 20 Nov 1608 d. 26 Dec 1657
4
George Booth
[1.1.1.1]
b. 8 Mar 1631
4
Elizabeth Booth
[1.1.1.2]
b. 6 Feb 1633 d. 13 Feb 1633
4
Mary Booth
[1.1.1.3]
b. 26 Mar 1633
+
William Fennet
4
John Booth
[1.1.1.4]
b. 23 Feb 1634 d. 1719
Mary Lodington
b. 1650 bur. 25 Jun 1740
5
John Booth, Jr
[1.1.1.4.1]
b. Feb 1673 d. 3 Oct 1723
Elizabeth Lamson
b. Abt 1695
6
John Senior
[1.1.1.4.1.1]
c. 2 Sep 1717
6
Elizabeth Senior
[1.1.1.4.1.2]
c. 25 Jul 1719
6
Robert Senior
[1.1.1.4.1.3]
c. 8 Jun 1722
6
Elizabeth Senior
[1.1.1.4.1.4]
c. 1 Nov 1723
6
Ann Senior
[1.1.1.4.1.5]
c. 4 Apr 1725
5
Elizabeth Booth
[1.1.1.4.2]
b. 1674
5
Marie Booth
[1.1.1.4.3]
b. 1675 d. 17 Jan 1732
Charles Newcomen
b. 1670 d. 1714
6
Mary Newcomen
[1.1.1.4.3.1]
b. 17 Nov 1702 d. 30 Apr 1719
6
John Newcomen
[1.1.1.4.3.2]
b. 1704 d. 8 Feb 1707
6
Charles Newcomen
[1.1.1.4.3.3]
b. 10 Mar 1706 d. 21 Jul 1767
6
Richard Newcomen
[1.1.1.4.3.4]
c. 17 Sep 1707 d. 3 Apr 1708
6
Esther Newcomen
[1.1.1.4.3.5]
c. 17 Sep 1707 d. 16 Apr 1708
6
Nicholas Newcomen
[1.1.1.4.3.6]
b. 25 Nov 1708 d. 18 Sep 1711
6
John Newcomen
[1.1.1.4.3.7]
b. 15 Jun 1710 d. 16 Jun 1710
6
Samuel Newcomen
[1.1.1.4.3.8]
b. 4 Jul 1711
6
Ann Newcomen
[1.1.1.4.3.9]
b. 4 Oct 1712 d. 13 Sep 1717
6
George Newcomen
[1.1.1.4.3.10]
b. 25 Feb 1714
5
Anne Booth
[1.1.1.4.4]
b. 1677 d. 21 Jan 1745
Edward Taylour
b. 1685
6
Amy Taylour
[1.1.1.4.4.1]
c. 27 Mar 1717
Henry Clulee
b. 1 Jul 1704
7
Edward Cluley
[1.1.1.4.4.1.1]
c. 8 Jul 1739
7
John Cluley
[1.1.1.4.4.1.2]
b. 1745 d. 28 Jan 1823
Sarah Hewett
c. 9 Sep 1750 d. 11 Jan 1840
8
Edward Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.1]
b. 28 Apr 1771 d. 9 Dec 1851
Sarah
b. Abt 1773
9
Amy Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.1.1]
b. 9 Mar 1794
9
Henry Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.1.2]
c. 2 Aug 1795
Elizabeth
b. 1778 d. 25 Jul 1840
9
Margery Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.1.3]
b. 1798
9
Jane Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.1.4]
c. 27 Mar 1803 d. 1884
9
John Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.1.5]
c. 17 Jan 1808 d. 13 Jul 1822
9
Richard Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.1.6]
c. 17 Jan 1808
9
Sarah Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.1.7]
c. 8 Apr 1810 bur. 10 Jan 1834
9
Elizabeth Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.1.8]
c. 23 May 1813
8
Elizabeth Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.2]
b. 28 May 1773 bur. 24 May 1833
8
Henry Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.3]
c. 30 Jan 1776 d. 24 May 1833
Sarah Smith
c. 4 Feb 1774 d. 1818
9
John Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.3.1]
b. 5 Mar 1801 d. 6 Mar 1802
9
Joseph Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.3.2]
b. 16 Jun 1803 d. 19 Aug 1807
9
John Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.3.3]
b. 3 Feb 1805 d. 1852
Rhoda Bishop
b. Abt 1805 bur. 3 Mar 1837
10
Thomas Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.1]
b. Jul 1819 d. 16 Jan 1900
Rebecca Harrison
b. 11 Sep 1823 d. 1905
11
Emma Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.1.1]
b. 13 Jul 1856 d. Jun 1878
John Mogg
b. 1 Jan 1851 d. 1 Sep 1920
12
Mary Jane Mogg
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.1.1.1]
b. 10 Feb 1875 d. 13 Jul 1949 [
=>
]
12
Emma Mogg
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.1.1.2]
b. 2 Mar 1878 d. 28 Aug 1948
11
Mary Ann Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.1.2]
b. 25 Apr 1858
11
Thomas Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.1.3]
b. 23 Oct 1862
Mary Ann Robinson
b. Abt 1861
12
Florence Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.1.3.1]
b. Abt 1889
12
Mary Ann Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.1.3.2]
b. 9 Mar 1891
11
Rebecca Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.1.4]
b. Abt 1865
10
John Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.2]
b. 14 Jul 1822 d. 30 Sep 1890
Jemima Mann
b. 13 Apr 1817 d. 1903
11
Hannah Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.2.1]
b. 1842
11
James Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.2.2]
b. 29 Aug 1852 d. 6 Jan 1918
Arrabella Benson
b. 1853
12
John Frederick Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.2.2.1]
b. 1873 d. 1876
12
Mary Ann Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.2.2.2]
b. 1 Nov 1874 d. 1876
12
Clara Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.2.2.3]
b. 25 Dec 1877
12
Edith Clulee
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.2.2.4]
b. 25 Dec 1879 d. 1880
12
Lily Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.2.2.5]
b. 25 Dec 1883
12
Minnie Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.2.2.6]
b. 7 Aug 1886 d. 1886
12
Eva Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.2.2.7]
b. 4 Mar 1888
12
Ethel Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.2.2.8]
b. 6 Oct 1892
12
Bertha Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.2.2.9]
b. 1895
11
Clara Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.2.3]
b. 29 Aug 1852
David Barford
b. 1852
12
Clara Barford
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.2.3.1]
b. 1874 d. 1890
12
Florence Maud Barford
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.2.3.2]
b. 1883 d. 1884
12
Harriet Myrtle Barford
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.2.3.3]
b. 1887
11
Rhoda Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.2.4]
b. 4 Jun 1854 d. 4 May 1885
Henry Hessay
b. 2 Feb 1834
12
Harriet Hessay
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.2.4.1]
b. 1878
12
Willliam Henry Hessay
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.2.4.2]
b. 1880 d. 1880
12
John Hessay
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.2.4.3]
b. 1882
12
George Hessay
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.2.4.4]
b. 1885 d. 6 Sep 1887
11
Mary Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.2.5]
b. 1859
10
Harry Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.3]
b. 23 May 1824 d. 4 Jun 1825
10
Rebecca Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.4]
b. 2 Apr 1826 d. 1908
William Smallwood
b. 3 Dec 1828 d. 1866
11
Rhoda Smallwood
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.4.1]
b. 20 Jul 1851 d. Dec 1928
Samuel Hackett
b. 1849 d. 1911
12
Jane Sophia Hackett
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.4.1.1]
c. 10 Jul 1870
12
Samuel Isaac Hackett
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.4.1.2]
c. 13 Apr 1873
12
Annie Rebecca Hackett
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.4.1.3]
b. 1875 [
=>
]
12
John William Hackett
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.4.1.4]
c. 10 Oct 1880
12
Martha A Hackett
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.4.1.5]
b. 1880
12
Thomas E Hackett
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.4.1.6]
b. 1883 d. Dec 1934
12
Frances M Hackett
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.4.1.7]
b. Abt 1887
12
Walter Harry Hackett
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.4.1.8]
b. Jul 1889 d. 15 Mar 1944
12
Alfred Ernest Hackett
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.4.1.9]
b. 1893
11
Baron Arthur Smallwood
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.4.2]
b. Abt 1852
Jane
b. Abt 1845 d. 1891
12
Louisa Smallwood
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.4.2.1]
b. Abt 1877
Amelia Challis
b. 1853
12
Dorothea Amy Smallwood
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.4.2.2]
b. 1896
12
Baron Alfred Smallwood
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.4.2.3]
b. 1898
11
Fanny Smallwood
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.4.3]
b. 15 Feb 1854 d. 1904
+
John Tallis
b. 1851
11
Catherine Smallwood
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.4.4]
b. 15 Feb 1857 d. Jul 1886
John Warden
b. 23 Jan 1853 d. Bef 1891
12
Ellen Warden
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.4.4.1]
b. Dec 1877 d. 1922 [
=>
]
12
Cathrine Warden
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.4.4.2]
b. Abt 1879
12
Lily Warden
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.4.4.3]
b. Abt 1883
12
Violet Adelaide Warden
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.4.4.4]
b. 20 Dec 1884 d. 1975 [
=>
]
11
William Smallwood
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.4.5]
b. 14 Oct 1861
+
Mary Wooliscroft
b. 1859
11
Mary Ann Smallwood
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.4.6]
c. 22 Sep 1867
11
Martha Louisa Smallwood
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.4.7]
c. 24 Sep 1871 d. Dec 1961
George Henry Cranmer
b. Jul 1869 d. 18 Jul 1940
12
George Reginalds Cranmer
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.4.7.1]
b. 26 Dec 1897 d. Jun 1981
10
Mary Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.5]
b. 27 Jan 1828 d. 1893
+
Charles Ainsworth
b. 1832
10
Martha Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.3.3.6]
b. 17 Oct 1830
9
Henry Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.3.4]
c. 18 Jan 1807 d. 19 Aug 1840
Catherine Threlfall
b. 1805 d. 1919
10
John Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.3.4.1]
b. 17 Jul 1829 bur. 8 Mar 1830
10
Sarah Priscilla Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.3.4.2]
b. 13 Feb 1831 d. 13 Apr 1865
Joseph Greaves
b. 22 Feb 1832 d. 19 Jun 1904
11
John Cluley Greaves
[1.1.1.4.4.1.2.3.4.2.1]
b. 21 Dec 1854 d. 8 Oct 1933
Althea Card
b. 6 Dec 1860 d. 28 Jan 1944
12
John Card Greaves
[1.1.1.4.4.1.2.3.4.2.1.1]
b. 29 Aug 1877 d. 15 Apr 1955 [
=>
]
12
Hattie Greaves
[1.1.1.4.4.1.2.3.4.2.1.2]
b. 15 Sep 1879 d. 11 Mar 1943 [
=>
]
12
Cyrus LeRoy Greaves
[1.1.1.4.4.1.2.3.4.2.1.3]
b. 19 Sep 1882 d. 21 Dec 1951 [
=>
]
12
Edwin Greaves
[1.1.1.4.4.1.2.3.4.2.1.4]
b. 23 Nov 1884 d. 27 Nov 1884
12
Myrtle Greaves
[1.1.1.4.4.1.2.3.4.2.1.5]
b. 27 Oct 1886 d. 26 Feb 1953 [
=>
]
12
Harley Greaves
[1.1.1.4.4.1.2.3.4.2.1.6]
b. 13 Jul 1889 d. 16 Aug 1976 [
=>
]
12
Card Greaves
[1.1.1.4.4.1.2.3.4.2.1.7]
b. 2 Feb 1894 d. 12 Feb 1977
11
Elizabeth Cluley Greaves
[1.1.1.4.4.1.2.3.4.2.2]
b. 21 Oct 1856 d. 5 May 1942
David Cullen Eames
b. 1 Sep 1851 d. 9 Feb 1929
12
Edward Eames
[1.1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.1]
b. 21 Aug 1878 d. 21 Aug 1878
12
David Greaves Eames
[1.1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.2]
b. 29 Sep 1879 d. 27 Jan 1961 [
=>
]
12
Sarah Greaves Eames
[1.1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.3]
b. 1 Nov 1881 d. 27 Nov 1970 [
=>
]
12
Elizabeth Greaves "Lillie" Eames
[1.1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.4]
b. 6 Jun 1884 d. 28 Dec 1966 [
=>
]
12
Rebecca May Eames
[1.1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.5]
b. 28 Dec 1886 d. 25 Jul 1955 [
=>
]
12
Aerial Guy Eames
[1.1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.6]
b. 18 Jul 1889 d. 27 Jan 1971 [
=>
]
12
Nathaniel Howard Eames
[1.1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.7]
b. 3 Aug 1892 d. 27 Jan 1921 [
=>
]
12
Joseph Leland Eames
[1.1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.8]
b. 23 Jun 1895 d. 12 Feb 1970 [
=>
]
12
Rowland Eames
[1.1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.9]
b. 14 May 1898 d. 16 May 1898
12
Ilah Eames
[1.1.1.4.4.1.2.3.4.2.2.10]
b. 8 Jun 1902 d. 17 May 1994 [
=>
]
11
Joseph Cluley Greaves
[1.1.1.4.4.1.2.3.4.2.3]
b. 1 Dec 1858 d. 16 Nov 1884
Catherine Mary Eames
b. 20 Sep 1855 d. 31 May 1931
12
Joseph Eames Greaves
[1.1.1.4.4.1.2.3.4.2.3.1]
b. 2 Nov 1880 d. 6 Jun 1954 [
=>
]
12
Olive Eames Greaves
[1.1.1.4.4.1.2.3.4.2.3.2]
b. 6 May 1883 d. Apr 1884
12
Oliver Eames Greaves
[1.1.1.4.4.1.2.3.4.2.3.3]
b. 6 May 1883 d. 13 Oct 1971 [
=>
]
11
Thomas Cluley Greaves
[1.1.1.4.4.1.2.3.4.2.4]
b. 2 Nov 1860 d. 5 May 1920
Hannah Kidd
b. 22 Mar 1864 d. 29 Nov 1910
12
Ethel Greaves
[1.1.1.4.4.1.2.3.4.2.4.1]
b. 11 May 1888 d. 12 Oct 1975 [
=>
]
12
Thomas Kidd Greaves
[1.1.1.4.4.1.2.3.4.2.4.2]
b. 1 Jan 1890 d. 4 Feb 1973 [
=>
]
12
Levean Greaves
[1.1.1.4.4.1.2.3.4.2.4.3]
b. 20 Apr 1892 d. 17 Jan 1962
12
Cluely Kidd Greaves
[1.1.1.4.4.1.2.3.4.2.4.4]
b. 19 Oct 1894 d. 6 May 1978 [
=>
]
12
Daughter Greaves
[1.1.1.4.4.1.2.3.4.2.4.5]
b. 2 Mar 1897
12
Seymour Kidd Greaves
[1.1.1.4.4.1.2.3.4.2.4.6]
b. 29 Jul 1903 d. 3 Feb 1990 [
=>
]
12
Thelma Greaves
[1.1.1.4.4.1.2.3.4.2.4.7]
b. 11 May 1906 d. 22 Jan 1908
12
Aleda Greaves
[1.1.1.4.4.1.2.3.4.2.4.8]
b. 8 Apr 1908 d. 20 Jul 1908
12
Donald Kidd Greaves
[1.1.1.4.4.1.2.3.4.2.4.9]
b. 20 Jan 1910 d. 18 Aug 1996
Alice Sina Jensen
b. 16 Apr 1876 d. 22 Mar 1963
12
Vaughn Jensen Greaves
[1.1.1.4.4.1.2.3.4.2.4.10]
b. 20 Dec 1913 d. 22 Jan 2008 [
=>
]
12
Leo Jensen Greaves
[1.1.1.4.4.1.2.3.4.2.4.11]
b. 21 Mar 1916 d. 6 Jun 1988 [
=>
]
12
Elsie Jensen Greaves
[1.1.1.4.4.1.2.3.4.2.4.12]
b. 6 Nov 1919 d. 31 Mar 1996
11
Priscilla Cluley Greaves
[1.1.1.4.4.1.2.3.4.2.5]
b. 17 Mar 1863 d. 24 Feb 1917
Thomas Nelson Rowland
b. 12 Mar 1860 d. 6 Mar 1910
12
Thomas Greaves Rowland
[1.1.1.4.4.1.2.3.4.2.5.1]
b. 17 Feb 1886 d. 7 May 1953 [
=>
]
12
Edward Greaves Rowland
[1.1.1.4.4.1.2.3.4.2.5.2]
b. 28 Aug 1889 d. 28 Aug 1889
12
Leon Greaves Rowland
[1.1.1.4.4.1.2.3.4.2.5.3]
b. 12 Oct 1890 d. 28 Sep 1891
12
Lenora Rowland
[1.1.1.4.4.1.2.3.4.2.5.4]
b. 26 Oct 1894 d. 13 Apr 1912
12
Sarah Priscilla Rowland
[1.1.1.4.4.1.2.3.4.2.5.5]
b. 29 Oct 1898 d. 1 Dec 1979
11
Mary Ann Cluley Greaves
[1.1.1.4.4.1.2.3.4.2.6]
b. 2 Apr 1865 d. 8 Apr 1865
10
Ann Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.3.4.3]
c. 2 Jan 1828 bur. 26 Nov 1828
10
Joseph Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.3.4.4]
c. 28 Jun 1835 bur. 21 Feb 1836
10
Elizabeth Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.3.4.5]
c. 13 Feb 1837 bur. 5 Mar 1837
10
Henry Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.3.4.6]
c. 6 May 1838 d. 24 Feb 1839
8
John Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.4]
b. 15 Mar 1778 d. 11 May 1852
Mary Hughes
b. Abt 1778 d. 29 Sep 1813
9
William Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.4.1]
b. 27 Jun 1798
9
Ann Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.4.2]
b. 14 Sep 1800
9
John Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.4.3]
b. 7 Dec 1802
9
Sarah Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.4.4]
b. 24 Feb 1805
9
Elizabeth Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.4.5]
b. 15 Dec 1807
9
Mary Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.4.6]
b. 3 Jan 1813 bur. 26 Apr 1813
9
Jane Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.4.7]
c. 27 Mar 1803 d. 1884
8
Mary Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.5]
b. 13 Jan 1781
8
Sarah Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.6]
b. 13 Jan 1781
8
Richard Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.7]
b. 30 Nov 1783 d. 3 Sep 1834
+
Martha Lapworth
b. 29 Aug 1788
8
William Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8]
b. 30 Jul 1786 d. 6 Feb 1872
Anne Thorpe Geydon
b. 11 Jan 1803
9
William Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.1]
b. 2 Apr 1826 d. 28 Sep 1856
9
Abraham Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.2]
b. 4 Feb 1828 d. 28 Apr 1874
Sarah Morris
b. 24 Aug 1835 d. 24 Mar 1869
10
William Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.2.1]
b. 12 Feb 1860
10
Louisa Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.2.2]
b. 18 Sep 1861 d. 30 May 1920
Edward Thomas Handley, Jr
b. 16 May 1839 d. 6 Oct 1906
11
Alice Handley
[1.1.1.4.4.1.2.8.2.2.1]
b. 1895 d. 1895
11
Vera May Handley
[1.1.1.4.4.1.2.8.2.2.2]
b. 13 Sep 1896 d. 5 Jul 1967
Patrick Charles Paul Heaphy
b. 20 May 1885 d. 7 Feb 1952
12
Eric Edward Thomas Heaphy
[1.1.1.4.4.1.2.8.2.2.2.1]
b. 19 Jan 1920 d. 7 Jun 1984
12
Gerald Charles Heaphy
[1.1.1.4.4.1.2.8.2.2.2.2]
b. 6 Jul 1921 d. 19 Dec 1921
12
Maurice Patrick Heaphy
[1.1.1.4.4.1.2.8.2.2.2.3]
b. 3 Jun 1922 d. 2 Jun 1985 [
=>
]
12
Brian Aubrey Trevor Heaphy
[1.1.1.4.4.1.2.8.2.2.2.4]
b. 12 Oct 1923 d. 6 Jun 1999
12
Pauline Mary Heaphy
[1.1.1.4.4.1.2.8.2.2.2.5]
b. 21 Feb 1926 d. 4 Feb 1961
12
Betty Grace Heaphy
[1.1.1.4.4.1.2.8.2.2.2.6]
b. 13 Mar 1931 d. 20 Mar 1985
12
Val Heaphy
[1.1.1.4.4.1.2.8.2.2.2.7]
12
Beryl Heaphy
[1.1.1.4.4.1.2.8.2.2.2.8]
12
John Heaphy
[1.1.1.4.4.1.2.8.2.2.2.9]
12
Jessie Heaphy
[1.1.1.4.4.1.2.8.2.2.2.10]
11
Grace Handley
[1.1.1.4.4.1.2.8.2.2.3]
b. 16 Oct 1898 d. 28 Jan 1975
Edward Orlando Terry Tuck
b. 22 May 1893 d. 6 Oct 1958
12
Cushla Louise Terry Tuck
[1.1.1.4.4.1.2.8.2.2.3.1]
b. 24 Dec 1925 d. 1 May 2003 [
=>
]
12
Colleen Mary Terry Tuck
[1.1.1.4.4.1.2.8.2.2.3.2]
b. 25 Feb 1927 d. 11 Dec 1995 [
=>
]
12
Living
[1.1.1.4.4.1.2.8.2.2.3.3]
[
=>
]
12
Living
[1.1.1.4.4.1.2.8.2.2.3.4]
[
=>
]
11
Elsie Handley
[1.1.1.4.4.1.2.8.2.2.4]
b. 16 Oct 1898 d. 16 Oct 1898
10
Annie Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.2.3]
b. 24 Aug 1863 d. 17 Jun 1922
9
Harry Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.3]
b. 9 May 1830
Ann Brookes
b. Abt 1829
10
Alice Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.3.1]
b. 17 Oct 1864
John Baker
b. 1863 d. 1937
11
Alice Gertrude Baker
[1.1.1.4.4.1.2.8.3.1.1]
b. 1885
11
John Horace Baker
[1.1.1.4.4.1.2.8.3.1.2]
b. 9 Jun 1887 d. 20 Oct 1961
Elizabeth James
b. 21 Feb 1887 d. 21 Apr 1961
12
Horace Joseph Thomas Baker
[1.1.1.4.4.1.2.8.3.1.2.1]
b. 30 Sep 1914 d. 23 Aug 1978 [
=>
]
11
Edith Baker
[1.1.1.4.4.1.2.8.3.1.3]
b. Abt 1891
11
Dorothy Baker
[1.1.1.4.4.1.2.8.3.1.4]
b. Abt 1892 d. Abt 1910
11
Arthur Baker
[1.1.1.4.4.1.2.8.3.1.5]
b. Abt 1899
Maud
b. Abt 1900
12
Living
[1.1.1.4.4.1.2.8.3.1.5.1]
11
Harry Baker
[1.1.1.4.4.1.2.8.3.1.6]
b. Abt 1900
11
Florence Baker
[1.1.1.4.4.1.2.8.3.1.7]
b. Abt 1900
Len Parkes
b. Abt 1900
12
Living
[1.1.1.4.4.1.2.8.3.1.7.1]
10
Arthur Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.3.2]
b. Abt 1868
10
Fanny Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.3.3]
b. Abt 1872
10
Harry Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.3.4]
b. Abt 1875
Florence Amelia McCann
b. 1874
11
Arthur Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.3.4.1]
b. 1903
11
Florence Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.3.4.2]
b. 1906
11
Walter Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.3.4.3]
b. 1910
+
Nellie Camel
b. 1910
9
Richard Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.4]
b. 1 Jul 1832
Elizabeth Sedgwick
b. Abt 1833
10
Edward Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.4.1]
b. 1865
10
Alfred Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.4.2]
b. 1868 d. 1941
Ellen Elizabeth Wright
b. 1873
11
Wilfred Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.4.2.1]
b. 1895
11
Leonard Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.4.2.2]
b. 1898
11
Dorothy Elizabeth Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.4.2.3]
b. 1911
10
Arthur Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.4.3]
b. 20 Mar 1873
Mary Eliza Duffield
b. 1870
11
Arthur Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.4.3.1]
b. 1894
11
Minnie Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.4.3.2]
b. 1896
11
Elsie Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.4.3.3]
b. 1898
11
William Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.4.3.4]
b. 1899
Ruth Doody
b. 1900
12
Living
[1.1.1.4.4.1.2.8.4.3.4.1]
[
=>
]
11
Mary Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.4.3.5]
b. 1900
11
Beatrice Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.4.3.6]
b. 13 Aug 1902
Ernest Robert James
b. 1900
12
Beatrice Mary James
[1.1.1.4.4.1.2.8.4.3.6.1]
b. 1924 d. 1 May 1955
9
Edward Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.5]
b. 20 Jul 1834
Rachel Makin
b. 14 Dec 1833
10
William Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.5.1]
b. 1860
Mary Hannah Merchant
b. 1865
11
Alice Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.5.1.1]
b. 1883
11
Albert Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.5.1.2]
b. 1884
11
George H Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.5.1.3]
b. 1885
11
Lizzie Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.5.1.4]
b. 1888
11
Ethel Florence Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.5.1.5]
b. 1892
11
Edith Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.5.1.6]
b. 1898
11
Harold Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.5.1.7]
b. 1901
10
Annie Elizabeth Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.5.2]
b. 1861
10
Edward Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.5.3]
b. 1863
10
George Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.5.4]
b. 1865
10
Gertrude Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.5.5]
b. 1868
10
Thomas Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.5.6]
b. 1870 d. 1945
Elizabeth Maxfield
b. Abt 1869
11
Edward Samuel Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.5.6.1]
b. Abt 1890
11
Beatrice Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.5.6.2]
b. Abt 1895
11
Harold Henry Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.5.6.3]
b. Abt 1901
Rose Swan
b. 1905
12
Living
[1.1.1.4.4.1.2.8.5.6.3.1]
[
=>
]
10
Alice Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.5.7]
b. 1871
10
Eleanor Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.5.8]
b. 1873
10
Kate Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.5.9]
b. 1877
9
Thomas Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.6]
b. 26 Mar 1837 d. 1892
Emma Loffill
b. 15 Apr 1832 d. Oct 1905
10
Annie Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.6.1]
b. 1861
10
Emma J Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.6.2]
b. 1864
10
Thomas Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.6.3]
b. 1868
Elizabeth
b. Abt 1876
11
Thomas William Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.6.3.1]
b. 1900
10
Elizabeth Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.6.4]
b. 1872
10
Harry Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.6.5]
b. 1874
9
George Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.7]
b. 15 Nov 1840 d. 2 May 1907
Emma Taylor
b. Abt 1841
10
Ann Emma Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.7.1]
b. 20 Feb 1861 d. 1861
10
Emma Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.7.2]
b. Apr 1867 d. Jan 1895
10
Elizabeth Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.7.3]
b. 1869 d. 1913
9
Parker Thorpe Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.8]
b. 29 Aug 1843 d. 6 Jan 1853
9
Robert Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.9]
b. 5 Sep 1845
Emily Churchill
b. 1841 d. Jun 1871
10
Ann Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.9.1]
b. 1867
+
George Henry Palmer
b. Abt 1866
10
William George Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.9.2]
b. 1869
Fanny Singer
b. 1869
11
Arthur Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.9.2.1]
b. 1893
11
Albert Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.9.2.2]
b. 1895
11
Gilbert Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.9.2.3]
b. 1897
11
George Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.9.2.4]
b. 1900
11
Winifred Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.9.2.5]
b. 1902
11
Victor Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.9.2.6]
b. 1906
Elsie Bourne
b. 1904
12
Living
[1.1.1.4.4.1.2.8.9.2.6.1]
[
=>
]
11
Dorothy Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.9.2.7]
b. 1908
11
Ethel Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.9.2.8]
b. 1911
Ellen Stevens
b. 1837
10
Minnie Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.9.3]
b. 1874
10
Sarah Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.9.4]
b. 1876
10
Ellen Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.9.5]
b. 1878
10
Emma Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.8.9.6]
b. 1881
8
Ann Cluley
[1.1.1.4.4.1.2.9]
b. 20 May 1793 d. Abt 1831
William Holdham
b. Abt 1793
9
Samuel Holdham
[1.1.1.4.4.1.2.9.1]
b. Feb 1819
9
John Holdham
[1.1.1.4.4.1.2.9.2]
b. Apr 1821 d. 17 Mar 1822
9
William Holdham
[1.1.1.4.4.1.2.9.3]
b. 22 Oct 1826
9
Charles Holdham
[1.1.1.4.4.1.2.9.4]
b. 22 Oct 1826
9
Mary Holdham
[1.1.1.4.4.1.2.9.5]
b. Apr 1830
5
William Booth
[1.1.1.4.5]
b. 1678 d. 18 Oct 1707
5
Thomas Booth
[1.1.1.4.6]
b. 1680
Anne Penyston
b. 1638 d. May 1668
5
Mary Booth
[1.1.1.4.7]
b. 1662
5
Anne Booth
[1.1.1.4.8]
b. 1663
5
Martha Booth
[1.1.1.4.9]
c. 3 Nov 1665 d. 24 Apr 1722
4
William Booth
[1.1.1.5]
b. 17 Jul 1636 d. 28 Nov 1652
4
Thomas Booth
[1.1.1.6]
b. 3 Oct 1637
+
Elizabeth Middlemore
b. 1641
4
Edmund Booth
[1.1.1.7]
b. 12 Nov 1637
4
Marmaduke Booth
[1.1.1.8]
b. 23 May 1639 d. 2 Mar 1640
4
Anne Booth
[1.1.1.9]
b. 9 Aug 1640 d. 11 Aug 1640