Home Page
|
What's New
|
Photos
|
Histories
|
Headstones
|
Reports
|
Surnames
Search
First Name:
Last Name:
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Suomalainen
Svenska
Kate
Abt 1565 -
Submit Photo / Document
Individual
Descendants
Relationship
Timeline
Submit Photo / Doc
Worksheet
Family
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Kate
[1]
b. Abt 1565
William Bolwell
b. Abt 1564
2
Rebecca Bolwell
[1.1]
c. 25 Jul 1590
2
Sarah Bolwell
[1.2]
b. 24 Dec 1592 d. 31 May 1676
Thomas Woodman
b. 1577 d. 16 Jul 1654
3
Sarah Woodman
[1.2.1]
b. 5 Jan 1621 d. Aft 1684
John Thompson
b. 5 Jan 1619 d. 9 Nov 1685
4
Mehitable Thompson
[1.2.1.1]
b. 1644 d. 1700
Samuel Hayward
b. 4 Jan 1642 d. 29 Jul 1713
5
Jonathan Haywood
[1.2.1.1.1]
b. Abt 1667
5
William Hayward
[1.2.1.1.2]
b. 6 Oct 1667
+
Priscilla Marsh
d. 10 Aug 1727
5
Mehitable Hayward
[1.2.1.1.3]
b. Abt 1669 d. 16 Dec 1713
Abraham Staples
b. 20 Oct 1638 d. 20 Oct 1703
6
Mehitable Staples
[1.2.1.1.3.1]
b. 20 Mar 1692 d. 7 Apr 1753
6
Jane Staples
[1.2.1.1.3.2]
b. 1694 d. 1707
6
Mary Staples
[1.2.1.1.3.3]
b. 1697 d. 2 May 1766
6
Elizabeth Staples
[1.2.1.1.3.4]
b. 3 Jun 1698 d. 3 Mar 1788
Nicholas Cook
b. 10 Jun 1687 d. 26 Apr 1779
7
Jemima Cook
[1.2.1.1.3.4.1]
b. 16 Nov 1716 d. 16 Oct 1815
Aaron Thayer
b. 11 Nov 1715 d. 28 Apr 1785
8
Elisabeth Thayer
[1.2.1.1.3.4.1.1]
b. 29 Oct 1740
8
Jemima Thayer
[1.2.1.1.3.4.1.2]
b. 14 Sep 1742 d. 1764
8
Benjamin Thayer
[1.2.1.1.3.4.1.3]
b. 16 Apr 1744 d. 29 Jun 1826
8
Susanna Thayer
[1.2.1.1.3.4.1.4]
b. 23 Apr 1746 d. 4 Jan 1808
Henry Benson
b. 5 Dec 1743 d. 7 Dec 1777
9
Hannah Benson
[1.2.1.1.3.4.1.4.1]
b. 7 May 1764
+
Aaron Legg
9
Joanna Benson
[1.2.1.1.3.4.1.4.2]
b. 6 Jul 1766 d. 29 Dec 1820
Daniel Holbrook
b. 7 Feb 1765 d. 10 Jun 1831
10
Henry Benson Holbrook
[1.2.1.1.3.4.1.4.2.1]
b. 21 Aug 1788 d. 1870
Rebecca Austin
b. 27 Oct 1796
11
Isaac Holbrook
[1.2.1.1.3.4.1.4.2.1.1]
b. 7 Nov 1816 d. 19 Apr 1875
11
Betsy Holbrook
[1.2.1.1.3.4.1.4.2.1.2]
b. 1821 d. 6 Dec 1897
11
Francis M Holbrook
[1.2.1.1.3.4.1.4.2.1.3]
b. 20 Jul 1823 d. 7 May 1906
Arlina M Raymond
b. 4 Apr 1831 d. 1903
12
Byron D Holbrook
[1.2.1.1.3.4.1.4.2.1.3.1]
b. 15 Oct 1847 d. 26 Jan 1848
12
Mary Eugenia Holbrook
[1.2.1.1.3.4.1.4.2.1.3.2]
b. 10 Jan 1850 d. 29 Aug 1875 [
=>
]
12
Fanny Maria Holbrook
[1.2.1.1.3.4.1.4.2.1.3.3]
b. 19 Dec 1853 d. 1881 [
=>
]
12
Henry B Holbrook
[1.2.1.1.3.4.1.4.2.1.3.4]
b. 24 Jan 1856 d. 9 Sep 1862
12
James R Holbrook
[1.2.1.1.3.4.1.4.2.1.3.5]
b. 19 Mar 1861 d. 9 Apr 1862
12
Bertha Arlina Holbrook
[1.2.1.1.3.4.1.4.2.1.3.6]
b. 24 Jan 1865
11
Charles Holbrook
[1.2.1.1.3.4.1.4.2.1.4]
b. 1834
10
Marcus Holbrook
[1.2.1.1.3.4.1.4.2.2]
b. Abt 1791 d. Aft 1840
+
Abigail Wild
10
Lydia Holbrook
[1.2.1.1.3.4.1.4.2.3]
b. Abt 1793 d. 19 Feb 1820
10
Daniel Holbrook
[1.2.1.1.3.4.1.4.2.4]
b. 28 Feb 1796 d. 18 Oct 1864
10
Rufus Holbrook
[1.2.1.1.3.4.1.4.2.5]
b. Abt 1801
Mary Wyman
b. 1801
11
Atward D Holbrook
[1.2.1.1.3.4.1.4.2.5.1]
b. 1831 d. 1900
Harriet Crehore
b. 3 Feb 1831 d. 4 Jan 1910
12
Hattie L Holbrook
[1.2.1.1.3.4.1.4.2.5.1.1]
b. 1857 d. 1860
10
Abraham Staples Holbrook
[1.2.1.1.3.4.1.4.2.6]
b. Abt 1806 d. 1 May 1862
+
Sally Dearborn
b. 22 Jun 1807 d. 20 Mar 1863
10
Millins Holbrook
[1.2.1.1.3.4.1.4.2.7]
b. Abt 1808
Laura Temple
b. 5 May 1808 d. 12 Sep 1864
11
Harriet Elizabeth Holbrook
[1.2.1.1.3.4.1.4.2.7.1]
b. 14 Jan 1835
Levi W Wellington
b. Oct 1829
12
Lillian Wellington
[1.2.1.1.3.4.1.4.2.7.1.1]
b. Abt 1856 [
=>
]
12
Frank L Wellington
[1.2.1.1.3.4.1.4.2.7.1.2]
b. Abt 1857 [
=>
]
12
Carlton G Wellington
[1.2.1.1.3.4.1.4.2.7.1.3]
b. 12 Nov 1859 d. 12 Jul 1937 [
=>
]
12
Ivan R Wellington
[1.2.1.1.3.4.1.4.2.7.1.4]
b. Sep 1879
11
Daniel Henry Holbrook
[1.2.1.1.3.4.1.4.2.7.2]
b. 9 Feb 1841
11
Fanny Maria Holbrook
[1.2.1.1.3.4.1.4.2.7.3]
b. 24 Dec 1841
11
George Benson Holbrook
[1.2.1.1.3.4.1.4.2.7.4]
b. Sep 1846 d. 4 Jul 1922
Ellen Beebe
b. 1852
12
George Millins Holbrook
[1.2.1.1.3.4.1.4.2.7.4.1]
b. 27 Jan 1870 d. 21 Feb 1935 [
=>
]
12
Emma L Holbrook
[1.2.1.1.3.4.1.4.2.7.4.2]
b. 17 Oct 1871 d. 15 Apr 1966
12
Elinor B Holbrook
[1.2.1.1.3.4.1.4.2.7.4.3]
b. 29 Jan 1885
9
Abigail Benson
[1.2.1.1.3.4.1.4.3]
b. 2 Jul 1768
+
Henry Staples
9
Henry Staples Benson
[1.2.1.1.3.4.1.4.4]
b. 8 Aug 1770 d. 29 Jul 1821
Lydia Sibley
b. 2 Apr 1769 d. 27 Nov 1822
10
Abigail Benson
[1.2.1.1.3.4.1.4.4.1]
b. 31 Mar 1795 d. 10 Nov 1821
Asa Legg
b. 7 May 1792 d. 15 Nov 1836
11
Charlotte Legg
[1.2.1.1.3.4.1.4.4.1.1]
b. 2 May 1818 d. 30 Oct 1900
George Perrier Stawitts
b. 3 Jul 1820 d. 1897
12
Jacob Stawitts
[1.2.1.1.3.4.1.4.4.1.1.1]
b. Abt 1844
12
Cornelius Stanton Stawitts
[1.2.1.1.3.4.1.4.4.1.1.2]
b. 17 Feb 1846 d. 2 May 1914 [
=>
]
12
Herbert Stawitts
[1.2.1.1.3.4.1.4.4.1.1.3]
b. Abt 1848 d. Abt 1852
12
Emma Stawitts
[1.2.1.1.3.4.1.4.4.1.1.4]
b. Abt 1850
11
Lyman Legg
[1.2.1.1.3.4.1.4.4.1.2]
b. 3 Sep 1822 d. 1 Sep 1904
Hannah Thayer
b. 11 Feb 1820
12
Enoch J Legg
[1.2.1.1.3.4.1.4.4.1.2.1]
b. 25 Sep 1846
12
Enda Isadore Legg
[1.2.1.1.3.4.1.4.4.1.2.2]
b. 25 Sep 1846 d. 1 Sep 1914
12
Sarah Thayer Legg
[1.2.1.1.3.4.1.4.4.1.2.3]
b. 20 Oct 1850
10
Harriet Benson
[1.2.1.1.3.4.1.4.4.2]
b. 14 Sep 1796 d. 22 Aug 1852
10
Mellen Benson
[1.2.1.1.3.4.1.4.4.3]
b. 14 Jan 1798
Eliza W Farnum
b. 25 Sep 1802 d. 14 Sep 1839
11
Henry Staples Benson
[1.2.1.1.3.4.1.4.4.3.1]
b. 17 May 1829
11
Almira Farnum Benson
[1.2.1.1.3.4.1.4.4.3.2]
b. 6 Aug 1830 d. 25 Dec 1835
11
James Haskins Benson
[1.2.1.1.3.4.1.4.4.3.3]
b. 16 Oct 1833
11
George Everett Benson
[1.2.1.1.3.4.1.4.4.3.4]
b. 14 Aug 1837
+
Mary Windsor Peck
b. 21 May 1798
10
Hannah Adaline Benson
[1.2.1.1.3.4.1.4.4.4]
b. 12 Aug 1802 d. 19 Jun 1822
10
Rufus Benson
[1.2.1.1.3.4.1.4.4.5]
b. 24 Jan 1804 d. 23 Aug 1805
10
Chloe Ann Benson
[1.2.1.1.3.4.1.4.4.6]
b. 23 Aug 1806
+
Dan Hill
b. 29 Nov 1796
10
Susan Augusta Benson
[1.2.1.1.3.4.1.4.4.7]
b. 9 Oct 1809 d. 25 Jul 1831
Preserved Smith Thayer
b. 9 May 1808
11
Susan Benson Thayer
[1.2.1.1.3.4.1.4.4.7.1]
b. 28 Jun 1831 d. 14 Aug 1909
+
Daniel Wheelock Aldrich
b. 28 Aug 1822 d. 23 May 1891
10
Rufus Aldrich Benson
[1.2.1.1.3.4.1.4.4.8]
b. 9 Oct 1809
+
Sarah E Buell
10
Stephen Sibley Benson
[1.2.1.1.3.4.1.4.4.9]
b. 9 Jan 1810 d. 20 Nov 1869
Elizabeth Richardson Scott
b. 8 Jan 1835 d. 20 Feb 1911
11
Jessie Harriet Benson
[1.2.1.1.3.4.1.4.4.9.1]
b. 7 Jun 1860
+
John Robert Forbes Love
b. 22 Jun 1856
11
Fred Mellen Benson
[1.2.1.1.3.4.1.4.4.9.2]
b. 10 Nov 1862 d. 9 May 1864
11
Susie Adeline Benson
[1.2.1.1.3.4.1.4.4.9.3]
b. 6 Aug 1865
9
Tirza Benson
[1.2.1.1.3.4.1.4.5]
b. 29 Apr 1772
Wilder Johnson
b. 1768
10
Elmira Johnson
[1.2.1.1.3.4.1.4.5.1]
b. 1810 d. 27 May 1816
9
Susanna Thayer Benson
[1.2.1.1.3.4.1.4.6]
b. 19 Feb 1775
+
Gideon Angel
b. Abt 1770
9
Rachel Benson
[1.2.1.1.3.4.1.4.7]
b. 5 May 1777 d. 21 Nov 1842
General Charles Jenckes
b. 7 Aug 1767 d. 4 Jul 1838
10
Charles Benson Jenckes
[1.2.1.1.3.4.1.4.7.1]
b. 10 Apr 1796 d. Aft 1831
Hannah Ellis Thayer
b. 19 Mar 1800 d. 26 Feb 1818
11
Charles T Jenckes
[1.2.1.1.3.4.1.4.7.1.1]
b. 20 Feb 1818 d. 28 Feb 1818
Urana Thayer
b. 26 Dec 1801 d. 15 Nov 1822
11
Rufus A Jenckes
[1.2.1.1.3.4.1.4.7.1.2]
b. 22 Sep 1822 d. 11 Oct 1822
+
Alice T Thayer
b. Abt 1802 d. 28 Mar 1826
Ann Eliza Smith
b. 31 Dec 1805 d. 2 Apr 1865
11
Hannah Eliza Jenckes
[1.2.1.1.3.4.1.4.7.1.3]
b. 25 Nov 1827 d. 22 Oct 1890
+
Edwin Smith
b. Abt 1825
11
Charles Henry Jenckes
[1.2.1.1.3.4.1.4.7.1.4]
b. 17 Nov 1829 d. 1862
Susan Jenks
b. Abt 1831 d. 1919
12
Anna Maria Jencks
[1.2.1.1.3.4.1.4.7.1.4.1]
b. 31 Dec 1851 d. 31 Jul 1910
12
Henry Benson Jencks
[1.2.1.1.3.4.1.4.7.1.4.2]
b. 12 Jan 1861 d. 20 Jan 1925 [
=>
]
11
Ann Mariah Jenckes
[1.2.1.1.3.4.1.4.7.1.5]
b. 31 Dec 1831 d. 31 Jul 1910
Dr James Lucas Wheaton
b. 14 Mar 1823
12
Martha Jenckes Wheaton
[1.2.1.1.3.4.1.4.7.1.5.1]
b. 12 Feb 1851 [
=>
]
12
Anna Francis Wheaton
[1.2.1.1.3.4.1.4.7.1.5.2]
b. 27 Feb 1853 [
=>
]
12
Jesse L Wheaton
[1.2.1.1.3.4.1.4.7.1.5.3]
b. Dec 1860
12
James Lucas Wheaton, Jr
[1.2.1.1.3.4.1.4.7.1.5.4]
b. 9 Jul 1868 [
=>
]
8
Rachel Thayer
[1.2.1.1.3.4.1.5]
b. 26 Mar 1748 d. 4 Jan 1802
8
Joanna Thayer
[1.2.1.1.3.4.1.6]
b. 16 Feb 1750
8
Urana Thayer
[1.2.1.1.3.4.1.7]
b. 12 Aug 1752 d. 19 Feb 1821
8
Elona Thayer
[1.2.1.1.3.4.1.8]
b. 19 May 1754
8
Lavina Thayer
[1.2.1.1.3.4.1.9]
b. 30 Jan 1756
8
Aaron Thayer, Jr
[1.2.1.1.3.4.1.10]
b. 26 Feb 1758 d. 9 Oct 1829
8
Elijah Thayer
[1.2.1.1.3.4.1.11]
b. 12 Aug 1760 d. 20 Sep 1764
8
Phebe Thayer
[1.2.1.1.3.4.1.12]
b. 17 Aug 1762 d. 1840
8
Hannah Thayer
[1.2.1.1.3.4.1.13]
b. Abt 1744
Pelatiah Thayer
b. 13 Oct 1739 d. 23 Mar 1797
9
Robert Thayer
[1.2.1.1.3.4.1.13.1]
b. 22 Nov 1763 d. 1830
9
Artemas Thayer
[1.2.1.1.3.4.1.13.2]
b. 20 Feb 1765 d. 1849
9
Henry Thayer
[1.2.1.1.3.4.1.13.3]
b. 19 Sep 1768 d. 1776
9
Smith P Thayer
[1.2.1.1.3.4.1.13.4]
b. 15 Dec 1770 d. 31 Mar 1818
9
Lavon Thayer
[1.2.1.1.3.4.1.13.5]
b. 14 Mar 1773
9
Laban Thayer
[1.2.1.1.3.4.1.13.6]
b. 19 Mar 1773 d. 1792
9
Putman Thayer
[1.2.1.1.3.4.1.13.7]
b. 15 Aug 1774 d. 14 Nov 1776
9
Henry Thayer
[1.2.1.1.3.4.1.13.8]
b. 3 Nov 1777 d. 7 Jul 1824
Urana Thompson
b. Abt 1778 d. 1859
10
Urana Thayer
[1.2.1.1.3.4.1.13.8.1]
b. 26 Dec 1801 d. 15 Nov 1822
Charles Benson Jenckes
b. 10 Apr 1796 d. Aft 1831
11
Rufus A Jenckes
[1.2.1.1.3.4.1.13.8.1.1]
b. 22 Sep 1822 d. 11 Oct 1822
10
Sarah Thayer
[1.2.1.1.3.4.1.13.8.2]
b. 1802 d. 23 Jul 1847
10
Alice Thayer
[1.2.1.1.3.4.1.13.8.3]
b. 1 Dec 1803 d. 29 Mar 1825
10
Betsey Thayer
[1.2.1.1.3.4.1.13.8.4]
b. 6 Mar 1806 d. 9 Mar 1809
10
Preserved Smith Thayer
[1.2.1.1.3.4.1.13.8.5]
b. 9 May 1808
Susan Augusta Benson
b. 9 Oct 1809 d. 25 Jul 1831
11
Susan Benson Thayer
[1.2.1.1.3.4.1.13.8.5.1]
b. 28 Jun 1831 d. 14 Aug 1909
+
Daniel Wheelock Aldrich
b. 28 Aug 1822 d. 23 May 1891
10
Henry Thayer
[1.2.1.1.3.4.1.13.8.6]
b. 9 Oct 1810
10
Nancy Thayer
[1.2.1.1.3.4.1.13.8.7]
b. 16 Oct 1815 d. 27 May 1831
10
Harriet Thayer
[1.2.1.1.3.4.1.13.8.8]
b. 7 Feb 1819
10
Hannah Thayer
[1.2.1.1.3.4.1.13.8.9]
b. 11 Feb 1820
Lyman Legg
b. 3 Sep 1822 d. 1 Sep 1904
11
Enoch J Legg
[1.2.1.1.3.4.1.13.8.9.1]
b. 25 Sep 1846
11
Enda Isadore Legg
[1.2.1.1.3.4.1.13.8.9.2]
b. 25 Sep 1846 d. 1 Sep 1914
+
Warren Henry Holt
b. 7 Dec 1847
11
Sarah Thayer Legg
[1.2.1.1.3.4.1.13.8.9.3]
b. 20 Oct 1850
10
Edward Davis Thayer
[1.2.1.1.3.4.1.13.8.10]
b. 22 Jul 1822 d. 12 May 1903
9
Mary Thayer
[1.2.1.1.3.4.1.13.9]
b. 3 Nov 1777
9
John Thayer
[1.2.1.1.3.4.1.13.10]
b. 20 Feb 1784 d. 5 Nov 1829
7
Nathaniel Cook
[1.2.1.1.3.4.2]
b. 18 Sep 1718 d. 17 Apr 1773
7
Peter Cook
[1.2.1.1.3.4.3]
b. 26 Aug 1720 d. 5 Jan 1811
Mercy Wanton
b. 29 Mar 1725 d. 20 Feb 1789
8
Mercy Cooke
[1.2.1.1.3.4.3.1]
b. 8 Jul 1746 d. 5 Jan 1825
Thomas Greene, Jr
b. 6 Dec 1745 d. 6 Oct 1829
9
Almy Greene
[1.2.1.1.3.4.3.1.1]
b. 16 Jan 1764 d. 29 Mar 1846
9
Mary Greene
[1.2.1.1.3.4.3.1.2]
b. 31 Oct 1765
9
Thomas Greene
[1.2.1.1.3.4.3.1.3]
b. Abt 1766
9
Job Greene
[1.2.1.1.3.4.3.1.4]
b. Abt 1768 d. 16 Jul 1849
9
John Greene
[1.2.1.1.3.4.3.1.5]
b. 6 May 1770 d. 1817
9
Sarah "Sally" Greene
[1.2.1.1.3.4.3.1.6]
b. 19 Oct 1773 d. 26 Nov 1855
9
Deborah Greene
[1.2.1.1.3.4.3.1.7]
b. 26 Aug 1774 d. 27 Jun 1846
9
Elizabeth Green
[1.2.1.1.3.4.3.1.8]
b. Abt 1777
9
Benjamin Greene
[1.2.1.1.3.4.3.1.9]
b. Abt 1777
9
Penelope Greene
[1.2.1.1.3.4.3.1.10]
b. Abt 1781 d. 17 Mar 1869
9
Mary Greene
[1.2.1.1.3.4.3.1.11]
b. Abt 1781
9
Penelope "Nelly" Greene
[1.2.1.1.3.4.3.1.12]
b. Abt 1781 d. 17 Mar 1869
9
Elizabeth Greene
[1.2.1.1.3.4.3.1.13]
b. 2 Feb 1782 d. 1 Jan 1859
9
Mercy Greene
[1.2.1.1.3.4.3.1.14]
b. 31 Oct 1785 d. 1 Jan 1859
8
Charles Cooke
[1.2.1.1.3.4.3.2]
b. 24 Sep 1747 d. 14 Jan 1817
8
Elizabeth Cooke
[1.2.1.1.3.4.3.3]
b. 23 Jul 1751 d. Apr 1780
8
Susanna Cooke
[1.2.1.1.3.4.3.4]
b. 14 Nov 1754 d. 13 Jun 1848
8
Constant Cooke
[1.2.1.1.3.4.3.5]
b. 11 Aug 1758 d. 6 Nov 1826
8
Hope Cooke
[1.2.1.1.3.4.3.6]
b. 12 Mar 1764 d. 25 Jul 1849
7
Daniel Cook
[1.2.1.1.3.4.4]
b. 12 Sep 1722 d. 5 Aug 1784
7
William Cook
[1.2.1.1.3.4.5]
b. 12 Dec 1724 d. 1790
7
Caleb Cook
[1.2.1.1.3.4.6]
b. 25 Sep 1727 d. 1788
7
Elisabeth Cook
[1.2.1.1.3.4.7]
b. 15 Jul 1729 d. 7 May 1804
7
Abigail Cook
[1.2.1.1.3.4.8]
b. 1 Nov 1731
7
Nicholas Cook
[1.2.1.1.3.4.9]
b. 7 Feb 1735 d. 15 Sep 1791
7
Susanna Cook
[1.2.1.1.3.4.10]
b. 6 Mar 1737 d. Sep 1748
6
Isaac Staples
[1.2.1.1.3.5]
b. 10 Jun 1699
6
Abraham Staples
[1.2.1.1.3.6]
b. 12 Apr 1702 d. Bef 3 Apr 1706
6
Abraham Staples
[1.2.1.1.3.7]
b. 3 Apr 1706 d. Aug 1767
Abigail Taft
b. 14 Sep 1707 d. 1736
7
Debarah Staples
[1.2.1.1.3.7.1]
b. 16 Oct 1727
7
Abigail Staples
[1.2.1.1.3.7.2]
b. 12 Oct 1729 d. 31 Dec 1813
Benoni Benson
b. 18 Jul 1724 d. 10 Jan 1806
8
Henry Benson
[1.2.1.1.3.7.2.1]
b. Abt 1778
8
Joseph Benson
[1.2.1.1.3.7.2.2]
b. Abt 1784
7
Abraham Staples
[1.2.1.1.3.7.3]
b. 4 Apr 1731 d. 20 Oct 1803
Marcy Harvey
b. 1 Jun 1731 d. 1772
8
Jonathan Staples
[1.2.1.1.3.7.3.1]
b. 29 Mar 1754 d. 28 Nov 1832
Rachel Holbrook
b. 6 Nov 1753 d. 9 Mar 1832
9
Sally Staples
[1.2.1.1.3.7.3.1.1]
b. 3 Oct 1779
9
Sylvia Staples
[1.2.1.1.3.7.3.1.2]
b. 2 Jan 1781 d. 13 Mar 1852
9
Rachael Staples
[1.2.1.1.3.7.3.1.3]
b. Abt 1784 d. 12 Dec 1870
9
Ellery Staples
[1.2.1.1.3.7.3.1.4]
b. 1784 d. 1861
9
Willard Staples
[1.2.1.1.3.7.3.1.5]
b. 20 Dec 1785 d. 20 Dec 1858
9
Jonathan Staples
[1.2.1.1.3.7.3.1.6]
b. 1792
8
George Staples
[1.2.1.1.3.7.3.2]
b. 9 Mar 1756 d. 23 Sep 1820
8
Abagail Staples
[1.2.1.1.3.7.3.3]
b. 9 Aug 1758 d. 1825
8
Lydia Staples
[1.2.1.1.3.7.3.4]
b. 5 Feb 1761 d. 12 Dec 1818
8
Abraham Staples
[1.2.1.1.3.7.3.5]
b. 13 Aug 1766
8
Jacob Staples
[1.2.1.1.3.7.3.6]
b. 2 Oct 1768
8
Mary Staples
[1.2.1.1.3.7.3.7]
b. 10 Mar 1772
Ruth Daniels
b. 13 Jul 1738 d. 26 Sep 1798
8
Ruth Staples
[1.2.1.1.3.7.3.8]
b. 22 Feb 1775 d. 10 Aug 1851
Elias Thayer
b. 3 May 1773 d. 26 Jun 1833
9
Hannah Ellis Thayer
[1.2.1.1.3.7.3.8.1]
b. 19 Mar 1800 d. 26 Feb 1818
Charles Benson Jenckes
b. 10 Apr 1796 d. Aft 1831
10
Charles T Jenckes
[1.2.1.1.3.7.3.8.1.1]
b. 20 Feb 1818 d. 28 Feb 1818
9
Ruth Daniels Thayer
[1.2.1.1.3.7.3.8.2]
b. 16 Jul 1802
9
Mary Blake Thayer
[1.2.1.1.3.7.3.8.3]
b. 26 Nov 1804 d. 1870
9
Elias Thayer
[1.2.1.1.3.7.3.8.4]
b. 28 Oct 1806 d. 2 Nov 1808
9
Julia Ann Thayer
[1.2.1.1.3.7.3.8.5]
b. 13 Dec 1808 d. 6 Aug 1833
9
Lyman Wheelock Thayer
[1.2.1.1.3.7.3.8.6]
b. 6 May 1798 d. 5 Apr 1848
9
Susan Thayer
[1.2.1.1.3.7.3.8.7]
b. 1 Feb 1811 d. 7 Apr 1812
9
Elias Nelson Thayer
[1.2.1.1.3.7.3.8.8]
b. 3 Apr 1814 d. 6 Aug 1835
9
John Milton Thayer
[1.2.1.1.3.7.3.8.9]
b. 24 Jan 1820 d. 19 Mar 1906
8
Lendol Staples
[1.2.1.1.3.7.3.9]
b. 1777
8
Susannah Staples
[1.2.1.1.3.7.3.10]
b. 21 Jul 1780 d. 11 Feb 1818
7
Lydia Staples
[1.2.1.1.3.7.4]
b. 1746 d. Abt 1843
Lydia White
b. 1 Mar 1726
7
Deborah Staples
[1.2.1.1.3.7.5]
b. 1741
7
Isaac Staples
[1.2.1.1.3.7.6]
b. 9 Mar 1742 d. 29 May 1848
Esther Benson
b. 8 Dec 1768 d. 31 Mar 1855
8
Esther Staples
[1.2.1.1.3.7.6.1]
b. Abt 1790 d. 17 May 1878
8
Abraham Staples
[1.2.1.1.3.7.6.2]
b. 12 Mar 1792 d. 5 Sep 1881
8
Scammel Staples
[1.2.1.1.3.7.6.3]
b. 29 Dec 1798 d. 5 Apr 1883
8
Warren Staples
[1.2.1.1.3.7.6.4]
b. 17 Jan 1802
8
Evaline Staples
[1.2.1.1.3.7.6.5]
b. 11 Aug 1807 d. 2 Oct 1858
7
Ruth Staples
[1.2.1.1.3.7.7]
b. 11 Jan 1744 d. 15 Dec 1819
7
Hammutal Staples
[1.2.1.1.3.7.8]
b. 16 Sep 1753
7
Nahor Staples
[1.2.1.1.3.7.9]
b. 3 Feb 1756 d. 9 Feb 1820
+
Nicholas Cook
b. 10 Jun 1687 d. 26 Apr 1779
5
Mary Hayward
[1.2.1.1.4]
b. Abt 1671 d. 20 Apr 1722
Joseph Rockwood
b. 27 May 1671 d. 1718
6
Mary Rockett
[1.2.1.1.4.1]
b. 31 Jul 1690
6
John Rockwood
[1.2.1.1.4.2]
b. 1692 d. Abt 1753
6
Joseph Rockwood
[1.2.1.1.4.3]
b. 4 Aug 1694 d. 1722
6
Margaret Rockwood
[1.2.1.1.4.4]
b. 4 Sep 1699 d. Abt 1750
6
Samuel Rockwood
[1.2.1.1.4.5]
b. 20 Dec 1700
6
Josiah Rockwood
[1.2.1.1.4.6]
b. 10 Sep 1702
6
Tiral Rockwood
[1.2.1.1.4.7]
b. 1 Jul 1704
6
Susanna Rockwood
[1.2.1.1.4.8]
b. Abt 1706 d. 30 Aug 1734
Daniel Cook
b. 18 Aug 1703 d. 18 Apr 1785
7
Tamasin Cook
[1.2.1.1.4.8.1]
b. 16 Jun 1725 d. 25 Apr 1804
James Ballou
b. 10 Dec 1723 d. 21 Jan 1812
8
Seth Ballou
[1.2.1.1.4.8.1.1]
b. 10 Feb 1748 d. 1778
8
Olive Ballou
[1.2.1.1.4.8.1.2]
b. 13 May 1751 d. 14 Apr 1845
8
Silas Ballou
[1.2.1.1.4.8.1.3]
b. 24 Feb 1753 d. 10 Feb 1837
8
Susanna Ballou
[1.2.1.1.4.8.1.4]
b. 16 Jun 1755
8
Ozial Ballou
[1.2.1.1.4.8.1.5]
b. 11 Jul 1757 d. 23 Jun 1838
8
Tamasin Ballou
[1.2.1.1.4.8.1.6]
b. Abt 1759
8
James Ballou
[1.2.1.1.4.8.1.7]
b. 25 Apr 1761 d. 30 Apr 1808
Mehitable Ingalls
b. 21 Jul 1764 d. 4 Dec 1821
9
James Ballon
[1.2.1.1.4.8.1.7.1]
b. 15 Oct 1794 d. 1839
9
Henry Ballon
[1.2.1.1.4.8.1.7.2]
b. 6 Sep 1796 d. 23 Feb 1857
9
Rufus Ballou
[1.2.1.1.4.8.1.7.3]
b. 15 Mar 1799 d. 5 Apr 1799
9
Mehitabel Ballou
[1.2.1.1.4.8.1.7.4]
b. 15 Mar 1799
9
Elizabeth Ballou
[1.2.1.1.4.8.1.7.5]
b. 21 Sep 1801 d. 21 Jan 1888
Abram Garfield
b. 28 Dec 1799 d. 8 May 1833
10
Mehetabel Garfield
[1.2.1.1.4.8.1.7.5.1]
b. 28 Jan 1821
10
Thomas Garfield
[1.2.1.1.4.8.1.7.5.2]
b. 16 Oct 1822
10
Mary Garfield
[1.2.1.1.4.8.1.7.5.3]
b. 19 Oct 1824
10
James Ballou Garfield
[1.2.1.1.4.8.1.7.5.4]
b. 21 Oct 1826 d. 8 Jan 1829
10
President James Abram Garfield
[1.2.1.1.4.8.1.7.5.5]
b. 19 Nov 1831 d. 19 Sep 1881
Lucretia "Crete" Rudolph
b. 19 Apr 1832 d. 14 Mar 1918
11
Eliza Arabella "Trot" Garfield
[1.2.1.1.4.8.1.7.5.5.1]
b. 3 Jul 1860 d. 3 Dec 1863
11
Harry Augustus Garfield
[1.2.1.1.4.8.1.7.5.5.2]
b. 11 Oct 1863 d. 12 Dec 1942
11
James Rudolph Garfield
[1.2.1.1.4.8.1.7.5.5.3]
b. 17 Oct 1865 d. 24 Mar 1950
11
Irvin McDowell Garfield
[1.2.1.1.4.8.1.7.5.5.4]
b. 3 Aug 1870 d. 18 Jul 1951
11
Abram Garfield
[1.2.1.1.4.8.1.7.5.5.5]
b. 21 Nov 1872 d. 16 Oct 1958
11
Mary "Molly" Garfield
[1.2.1.1.4.8.1.7.5.5.6]
b. 16 Jan 1867 d. 30 Dec 1947
11
Edward Garfield
[1.2.1.1.4.8.1.7.5.5.7]
b. 25 Dec 1874 d. 25 Oct 1876
8
Russell Ballou
[1.2.1.1.4.8.1.8]
b. 11 Jul 1763 d. 10 Nov 1847
8
Aaron Ballou
[1.2.1.1.4.8.1.9]
b. 25 Sep 1766 d. 1807
8
Daniel Ballou
[1.2.1.1.4.8.1.10]
b. 26 May 1768 d. Dec 1806
8
Priscilla Ballou
[1.2.1.1.4.8.1.11]
b. 3 Jan 1772 d. 10 Mar 1793
7
Ezekiel Cook
[1.2.1.1.4.8.2]
b. 5 Mar 1730 d. 7 Oct 1741
7
Daniel Cook
[1.2.1.1.4.8.3]
b. 7 Jun 1732 d. 6 Nov 1794
7
John Cook
[1.2.1.1.4.8.4]
b. 12 Apr 1738 d. 29 Oct 1741
7
Susanna Cook
[1.2.1.1.4.8.5]
b. 1743
6
Richard Rockwood
[1.2.1.1.4.9]
b. 10 Dec 1706 d. 1786
6
Benjamin Rockwood
[1.2.1.1.4.10]
b. 8 May 1711
5
Huldah Hayward
[1.2.1.1.5]
b. 28 May 1672
Benjamin B Butterworth
b. 31 Oct 1672 d. Abt 1711
6
Sarah Butterworth
[1.2.1.1.5.1]
b. 6 Feb 1693
6
Samuel Butterworth
[1.2.1.1.5.2]
b. 26 Dec 1695
6
Benjamin Butterworth
[1.2.1.1.5.3]
b. Abt 1703 d. 11 Mar 1718
5
Sarah Haywood
[1.2.1.1.6]
b. 2 Mar 1673 d. 8 Dec 1711
Benjamin Thayer
b. 1674 d. 1729
6
Rachel Thayer
[1.2.1.1.6.1]
b. 5 Mar 1700 d. 1759
Eleazer Taft
b. 5 Apr 1697 d. 29 Aug 1759
7
Aaron Taft
[1.2.1.1.6.1.1]
b. 20 Jul 1722 d. 24 Apr 1764
7
Moses Taft
[1.2.1.1.6.1.2]
b. 20 Jul 1722 d. 12 Nov 1791
7
Sarah Taft
[1.2.1.1.6.1.3]
b. 2 Nov 1727
7
Joshua Taft
[1.2.1.1.6.1.4]
b. 14 Jan 1731 d. 1770
6
Margaret Thayer
[1.2.1.1.6.2]
b. 17 Dec 1701 d. 20 Oct 1749
6
Grace Thayer
[1.2.1.1.6.3]
b. 6 May 1704
6
Sarah Thayer
[1.2.1.1.6.4]
b. 23 Mar 1706
6
Benjamin Thayer
[1.2.1.1.6.5]
b. 23 Sep 1707 d. 23 Feb 1708
6
Lydia Thayer
[1.2.1.1.6.6]
b. 24 Apr 1709
5
Margery Hayward
[1.2.1.1.7]
b. Abt 1675
Jacob Aldrich
b. 7 May 1676 d. 23 Aug 1753
6
Mercy Aldrich
[1.2.1.1.7.1]
b. 21 Jun 1700 d. Aft 19 Sep 1753
Israel Taft
b. 26 Apr 1699 d. 19 Sep 1753
7
Huldah Taft
[1.2.1.1.7.1.1]
b. 28 Jun 1718 d. 2 Jul 1799
David Daniels
b. 4 Jul 1710 d. 21 May 1776
8
Ruth Daniels
[1.2.1.1.7.1.1.1]
b. 13 Jul 1738 d. 26 Sep 1798
Jonathan Wheelock
b. 8 Sep 1731 d. 1774
9
Eleazer Wheelock
[1.2.1.1.7.1.1.1.1]
b. 15 Jul 1756 d. 1841
9
Dole Wheelock
[1.2.1.1.7.1.1.1.2]
b. 29 May 1758
9
Susannah Wheelock
[1.2.1.1.7.1.1.1.3]
b. 23 Feb 1760 d. 2 May 1776
9
Lyman Wheelock
[1.2.1.1.7.1.1.1.4]
b. 30 Nov 1761 d. 29 Mar 1848
9
Alphaeus Wheelock
[1.2.1.1.7.1.1.1.5]
b. 17 Dec 1763
9
Willard Wheelock
[1.2.1.1.7.1.1.1.6]
b. 19 Jun 1768 d. 29 Mar 1823
9
Deobrah Wheelock
[1.2.1.1.7.1.1.1.7]
b. 17 Dec 1765 d. 3 Aug 1846
Elkanah Benson
b. 21 Feb 1766 d. 8 Mar 1844
10
Samuel Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.1]
b. 21 May 1791
Mary Van Liew
b. 8 Jul 1797 d. 22 Apr 1859
11
William Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.1.1]
b. 18 Dec 1817
11
Emily Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.1.2]
b. 18 Dec 1817
+
George Van Heusen
b. 3 Jun 1816 d. 25 Mar 1872
11
Alzina Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.1.3]
b. 8 Nov 1819 d. 29 Mar 1867
+
Charles W Ingersoll
b. 1817
11
Augustus Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.1.4]
b. 10 Feb 1822
11
Phila Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.1.5]
b. 8 Mar 1824
William Jenkins
b. 1820 d. 14 May 1864
12
Walter Jenkins
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.1.5.1]
b. 1857 d. 14 May 1864
12
Emma Jenkins
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.1.5.2]
b. 1861
11
Nathan S Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.1.6]
b. 17 Sep 1826 d. 1869
Martha Mead
b. 1838
12
Cora Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.1.6.1]
b. Abt 1860
12
Florence E Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.1.6.2]
b. Feb 1862
12
Alice Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.1.6.3]
b. Abt 1864
12
Nellie Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.1.6.4]
b. Abt 1866
11
James Mapes Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.1.7]
b. 12 Jun 1828 d. 11 Oct 1907
Margaret Jane Williamson
b. 4 Dec 1834 d. 20 Feb 1905
12
Francis Coe Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.1.7.1]
b. 22 Feb 1860
12
James Clarence Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.1.7.2]
b. 24 May 1862 d. 12 Jul 1920 [
=>
]
11
Montgomery Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.1.8]
b. Abt 1833
11
Mary Ellen Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.1.9]
b. Abt 1839
+
Cyrus B Kinne
b. Jan 1835
10
Chloe Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.2]
b. 6 Jan 1793 d. 1882
Lewis Smith
b. Abt 1790
11
Mary Smith
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.2.1]
b. Abt 1813 d. 1913
+
Henry Gilman Darling
b. 16 Aug 1810 d. 17 Dec 1870
11
Sidney Smith
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.2.2]
b. 29 Jan 1815 d. 10 Sep 1900
Jennie Ann Calkins
b. 1835
12
Adelia Smith
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.2.2.1]
b. Apr 1866 [
=>
]
12
Anna Smith
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.2.2.2]
b. 1869
11
William Smith
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.2.3]
b. Abt 1817
11
Lewis Smith
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.2.4]
b. Abt 1820
11
Stephen Smith
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.2.5]
b. 19 Feb 1823 d. 26 Aug 1922
Lucy Colver
b. 13 Oct 1835 d. 12 Sep 1905
12
Florence Nightingale Smith
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.2.5.1]
b. 8 Nov 1861
12
Evangeline Smith
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.2.5.2]
b. Abt 1863 d. Abt 1868
12
Sidney Smith
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.2.5.3]
b. 23 Dec 1864
12
Caroline Smith
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.2.5.4]
b. 4 Aug 1866 d. 11 Mar 1868
12
Stephen Smith
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.2.5.5]
b. 27 Dec 1868 d. 8 Jan 1889
12
Evalyn C Smith
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.2.5.6]
b. 28 Dec 1868
12
Lucille Carroll Smith
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.2.5.7]
b. 30 Jan 1873
12
Dean Smith
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.2.5.8]
b. 28 Aug 1875
12
Anna Jaffray Smith
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.2.5.9]
b. 8 Jun 1878
11
Job Lewis Smith
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.2.6]
b. 15 Oct 1827 d. 9 Jun 1897
10
Adolphus Willard Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.3]
b. 17 Dec 1795 d. 18 May 1878
Hannah Vermilyea
b. 1796 d. 28 Jun 1886
11
Edward Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.3.1]
b. 1824
11
Bryon L Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.3.2]
b. 25 Dec 1825 d. 23 Oct 1912
Angelina Howard
b. 16 Jul 1836 d. 24 Nov 1922
12
Alice Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.3.2.1]
b. 15 Aug 1858 d. 19 May 1879
11
Lewis Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.3.3]
b. Abt 1827
11
Elizabeth Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.3.4]
b. Abt 1829
11
Ellen Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.3.5]
b. Abt 1831
11
John Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.3.6]
b. Abt 1833
11
Henry Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.3.7]
b. Abt 1835
11
Jane H Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.3.8]
b. Abt 1837
11
Frank Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.3.9]
b. Abt 1839
10
Eliza Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.4]
b. 9 Mar 1798 d. 13 Nov 1817
+
James Miller
b. Abt 1795
10
Leonard Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.5]
b. 7 Apr 1800 d. 7 Sep 1877
Ruth Ann Reynolds
b. 23 Jul 1805 d. 2 Feb 1853
11
Elisha Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.5.1]
b. 1829
Helen R Sherman
b. 1839
12
Hattie Isabel Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.5.1.1]
b. Abt 1860
12
Carrie A Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.5.1.2]
b. 4 Dec 1861 d. 1 Jul 1949 [
=>
]
12
Ida May Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.5.1.3]
d. Bef 1908
11
William R Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.5.2]
b. 1831 d. 26 Feb 1889
Lucy Ann Clark
b. 16 Dec 1836 d. 21 Feb 1903
12
Edith Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.5.2.1]
b. 1868
12
Melvin Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.5.2.2]
b. 1869 d. 1870
12
Eva L Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.5.2.3]
b. Mar 1875
11
John Thompson Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.5.3]
b. 25 May 1833 d. 2 Apr 1914
Louisa Clark
b. 18 Nov 1835 d. 23 Jan 1918
12
Jay Clark Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.5.3.1]
b. Aug 1856 d. 26 Aug 1937 [
=>
]
12
Leonard E Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.5.3.2]
b. Jun 1860 d. 3 Jan 1927
11
Emory J Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.5.4]
b. Jul 1836 d. 8 Mar 1926
Jane Ann Van Sickle
b. 20 Mar 1838
12
Ella L Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.5.4.1]
b. Abt 1863
12
Clarence Emery Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.5.4.2]
b. Jan 1870 [
=>
]
12
Alma Edna Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.5.4.3]
b. May 1880
+
Helen Rebecca Sherman
11
Finley E Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.5.5]
b. Abt 1841
Maria Higby
b. Abt 1843 d. Bef 1910
12
Marion Arthur Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.5.5.1]
b. 13 Nov 1868 d. Aft 28 Apr 1930 [
=>
]
12
Delbert Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.5.5.2]
b. Abt 1878
Hannah Sherman
11
Mary Isabelle Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.5.6]
b. 7 Jun 1853 d. 9 Dec 1935
Howard Spurgeon Green
b. 25 Aug 1850 d. 24 Jan 1912
12
Roy C Green
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.5.6.1]
b. 3 Nov 1879 d. Jul 1955 [
=>
]
12
Leonard Benson Green
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.5.6.2]
b. 10 Nov 1882 d. 24 Jul 1947
12
Helen Ione Green
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.5.6.3]
b. 23 Oct 1893
10
Phila Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.6]
b. 27 Jul 1802
Charles Warner
b. Abt 1800
11
Susan Warner
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.6.1]
b. 1828
11
Mary Warner
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.6.2]
b. 1830
11
Harriet Warner
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.6.3]
b. 1832
10
Calista Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.7]
b. 2 Jun 1804 d. 15 Sep 1882
Jacob Conklin
b. 19 Sep 1798 d. 1 Nov 1884
11
Sarah Conklin
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.7.1]
b. 1828
11
Edward Conklin
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.7.2]
b. Abt 1828
11
Sory Ann Conklin
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.7.3]
b. 1831 d. 7 Feb 1832
11
Benson Conklin
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.7.4]
b. May 1833
Tina Ann Roseboone
b. 1838
12
Ella Mary Abbott Conklin
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.7.4.1]
b. 16 May 1856
12
Frank B Conklin
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.7.4.2]
b. 1857
12
Gilbert Conklin
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.7.4.3]
b. 1859
12
Charles Conklin
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.7.4.4]
b. 1860 d. 6 Sep 1865
12
Lizzie Conklin
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.7.4.5]
b. 1862
12
Kittie E Conklin
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.7.4.6]
b. 1872
+
Della J Walsh
b. Feb 1838
11
John Conklin
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.7.5]
b. 1835 d. 25 Oct 1835
11
Maria Conklin
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.7.6]
b. 1837 d. 1850
11
Daughter Conklin
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.7.7]
b. 1840 d. 1840
11
Eugene Conklin
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.7.8]
b. 1841 d. 14 Apr 1912
Harriet Ann Van Etten
b. 1845 d. 2 Jun 1932
12
Nellie V Conklin
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.7.8.1]
b. 1872 d. 16 Sep 1893
12
Mary F Conklin
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.7.8.2]
b. 1881 d. 25 Aug 1960
11
Daughter Conklin
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.7.9]
b. 1843 d. 3 Mar 1843
11
Lewis Smith Conklin
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.7.10]
b. Nov 1845 d. 28 Feb 1905
Persis Wiggins
b. May 1848 d. 4 May 1920
12
Florence Conklin
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.7.10.1]
b. 1877 bur. 14 Aug 1894
12
Anna Bessie Conklin
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.7.10.2]
b. Apr 1877
12
Don J Conklin
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.7.10.3]
b. Oct 1880
12
Sarah C Conklin
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.7.10.4]
b. Sep 1888
11
Annette Conklin
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.7.11]
b. 1848 d. 22 Jun 1848
10
Ruth Wheelock Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.8]
b. 21 Sep 1807
William J Vermilyea
b. 7 Jul 1803 d. 30 Jun 1879
11
Francis Arvilla Vermilyea
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.8.1]
b. 19 Apr 1830 d. 19 Nov 1915
Isaac Fuller Camp
b. 11 Feb 1823 d. 10 Aug 1890
12
Edwin L Camp
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.8.1.1]
b. 13 Mar 1851
12
Ida M Vermilyea
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.8.1.2]
b. 8 Mar 1857
12
Hanna Ruth Camp
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.8.1.3]
b. 23 Apr 1859
12
Albert E Camp
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.8.1.4]
b. Nov 1862
12
Mary A Camp
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.8.1.5]
b. 1864
12
William Whitney Camp
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.8.1.6]
b. 5 Feb 1867
11
Emily Benson Vermilyea
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.8.2]
b. 6 Dec 1831 d. Jun 1902
William Henry Myers
b. 1827
12
William Franklin Myers
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.8.2.1]
b. 1855
12
Selina Delphenie Myers
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.8.2.2]
b. 1857
12
Elizabeth Lorma Myers
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.8.2.3]
b. 1860
12
Henrietta Lorma Myers
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.8.2.4]
b. 1862
12
Harriet Benson Myers
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.8.2.5]
b. 1869
12
Gertrude Lucinia Myers
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.8.2.6]
b. 1874
11
Sidney Smith Vermilyea
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.8.3]
b. 27 Oct 1835 d. 22 Dec 1929
Amanda Fluke
b. 31 May 1842 d. 31 Mar 1937
12
Owen C Vermilyea
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.8.3.1]
b. 20 Jul 1864 d. 1919 [
=>
]
12
Henry Arthur Vermilyea
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.8.3.2]
b. 12 Mar 1867 [
=>
]
12
Bert Vermilyea
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.8.3.3]
b. 4 Dec 1868 [
=>
]
12
Charles E Vermilyea
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.8.3.4]
b. 15 Jan 1871 [
=>
]
12
Edgar L Vermilyea
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.8.3.5]
b. 12 Oct 1874 [
=>
]
12
Mary A Vermilyea
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.8.3.6]
b. 2 Feb 1880 d. Abt 1981
11
Elkanah Benson Vermilyea
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.8.4]
b. 9 Sep 1837 d. 31 May 1838
11
Chauncey Vermilyea
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.8.5]
b. 25 Mar 1839 d. 16 Jun 1863
11
Eliza Prudence Vermilyea
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.8.6]
b. 4 Apr 1842 d. 1923
James Tytler Johnstone
c. 18 Oct 1840 d. 1913
12
Harry Vermilyea Johnstone
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.8.6.1]
b. 1872
12
Elizabeth Winifred Johnstone
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.8.6.2]
b. 1873
12
James Charles Johnstone
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.8.6.3]
b. 1875
12
John Harvey Johnstone
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.8.6.4]
b. 1877
12
James Benson Johnstone
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.8.6.5]
b. 1880
12
Donald Denny Johnstone
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.8.6.6]
b. 1884
11
John Benson Vermilyea
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.8.7]
b. 26 May 1844
+
Mary Elizabeth Frizzle
b. 1848
11
Albert Gallatin Vermilyea
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.8.8]
b. 15 Sep 1846
Samantha Sophia Crawford
b. 1850
12
Lillie Alice Vermilyea
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.8.8.1]
b. 26 Sep 1872
12
Carl Crawford Vermilyea
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.8.8.2]
b. 1 Feb 1874 [
=>
]
12
Daughter Vermilyea
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.8.8.3]
b. 1877 d. 1877
10
Sarah Elizabeth Benson
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.9]
b. 1 Jul 1809 d. 20 Jul 1888
Leicester Dodge
b. 28 Apr 1808 d. 5 Sep 1843
11
Ermina P Dodge
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.9.1]
b. 14 Feb 1831
+
Rufus Moe
11
Henry Benson Dodge
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.9.2]
b. 3 Oct 1832 d. 16 Feb 1914
Sally Betsey Howard
b. 27 Dec 1834 d. 15 Dec 1919
12
Emaline Elizabeth Dodge
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.9.2.1]
b. 29 Dec 1861 d. 1932
12
Ezra Leicester Dodge
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.9.2.2]
b. 22 Nov 1863 d. 3 Dec 1950
12
Benson Henry Dodge
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.9.2.3]
b. 15 Jan 1867 d. 25 Jun 1931 [
=>
]
12
Susan Louisa Dodge
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.9.2.4]
b. 28 May 1868 d. 8 Oct 1913
12
Hattie Blanche Dodge
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.9.2.5]
b. 25 Jun 1870 d. 1944 [
=>
]
11
Flora Elizabeth Dodge
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.9.3]
b. 6 Nov 1834
+
Horace Richards
11
Sarah Janette Dodge
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.9.4]
b. 20 Sep 1836
11
Calista Augusta Dodge
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.9.5]
b. 23 Nov 1838 d. 29 Aug 1884
+
William Alexander Gunsaullus
b. 15 Jul 1835 d. 27 Aug 1871
11
Caroline Emelia Dodge
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.9.6]
b. 30 Aug 1841 d. 7 Dec 1913
William Hadcill Carr
b. 13 Dec 1836 d. 19 Mar 1909
12
Florence A Carr
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.9.6.1]
b. 22 Jan 1864 d. 17 Feb 1904
12
Arthur Elmer Carr
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.9.6.2]
b. 19 Jun 1867 d. 20 Oct 1943
11
Lester Lewis Dodge
[1.2.1.1.7.1.1.1.7.9.7]
b. 30 Oct 1843
Abraham Staples
b. 4 Apr 1731 d. 20 Oct 1803
9
Ruth Staples
[1.2.1.1.7.1.1.1.8]
b. 22 Feb 1775 d. 10 Aug 1851
Elias Thayer
b. 3 May 1773 d. 26 Jun 1833
10
Hannah Ellis Thayer
[1.2.1.1.7.1.1.1.8.1]
b. 19 Mar 1800 d. 26 Feb 1818
Charles Benson Jenckes
b. 10 Apr 1796 d. Aft 1831
11
Charles T Jenckes
[1.2.1.1.7.1.1.1.8.1.1]
b. 20 Feb 1818 d. 28 Feb 1818
10
Ruth Daniels Thayer
[1.2.1.1.7.1.1.1.8.2]
b. 16 Jul 1802
10
Mary Blake Thayer
[1.2.1.1.7.1.1.1.8.3]
b. 26 Nov 1804 d. 1870
10
Elias Thayer
[1.2.1.1.7.1.1.1.8.4]
b. 28 Oct 1806 d. 2 Nov 1808
10
Julia Ann Thayer
[1.2.1.1.7.1.1.1.8.5]
b. 13 Dec 1808 d. 6 Aug 1833
10
Lyman Wheelock Thayer
[1.2.1.1.7.1.1.1.8.6]
b. 6 May 1798 d. 5 Apr 1848
10
Susan Thayer
[1.2.1.1.7.1.1.1.8.7]
b. 1 Feb 1811 d. 7 Apr 1812
10
Elias Nelson Thayer
[1.2.1.1.7.1.1.1.8.8]
b. 3 Apr 1814 d. 6 Aug 1835
10
John Milton Thayer
[1.2.1.1.7.1.1.1.8.9]
b. 24 Jan 1820 d. 19 Mar 1906
9
Lendol Staples
[1.2.1.1.7.1.1.1.9]
b. 1777
9
Susannah Staples
[1.2.1.1.7.1.1.1.10]
b. 21 Jul 1780 d. 11 Feb 1818
8
Daniel Daniels
[1.2.1.1.7.1.1.2]
b. 4 Nov 1740 d. 24 May 1832
Ruth Aldrich
b. 29 Jun 1741 d. 15 Jul 1801
9
Rachael Daniels
[1.2.1.1.7.1.1.2.1]
b. 24 Dec 1767 d. 11 Aug 1846
9
Nathan Daniels
[1.2.1.1.7.1.1.2.2]
b. 1769 d. 10 May 1839
9
Dianah Daniels
[1.2.1.1.7.1.1.2.3]
b. 1774
9
Hulda Daniels
[1.2.1.1.7.1.1.2.4]
b. 1776
9
Adolpheus Daniels
[1.2.1.1.7.1.1.2.5]
b. 1778
9
Waite Daniels
[1.2.1.1.7.1.1.2.6]
b. 1780
+
Nancy Thayer
b. Abt 1743 d. 10 Mar 1803
8
Molly Daniels
[1.2.1.1.7.1.1.3]
b. 1 Oct 1741 d. 13 Apr 1793
Seth Kelley
b. 26 Nov 1730 d. 29 Apr 1799
9
Seth Kelley
[1.2.1.1.7.1.1.3.1]
b. 10 Sep 1762 d. 27 Sep 1850
9
Mehitable Kelley
[1.2.1.1.7.1.1.3.2]
b. 30 Apr 1765 d. 4 Nov 1798
9
Lettice Kelley
[1.2.1.1.7.1.1.3.3]
b. 9 Jan 1768 d. 1 Feb 1843
9
Willis Kelley
[1.2.1.1.7.1.1.3.4]
b. 14 Jan 1770 d. 23 Dec 1826
9
Moses Kelley
[1.2.1.1.7.1.1.3.5]
b. 19 Oct 1771 d. 14 Sep 1776
9
Waite Kelley
[1.2.1.1.7.1.1.3.6]
b. 12 Aug 1773 d. 7 Mar 1781
9
Asa Kelley
[1.2.1.1.7.1.1.3.7]
b. 24 Mar 1775 d. 29 Apr 1852
9
John Kelley
[1.2.1.1.7.1.1.3.8]
b. 12 Dec 1776 d. 17 Aug 1866
9
Daniel Kelley
[1.2.1.1.7.1.1.3.9]
b. 23 Jul 1778 d. 23 Apr 1825
9
Mary Kelley
[1.2.1.1.7.1.1.3.10]
b. 6 Jul 1780 d. 26 Feb 1802
9
Mark Kelley
[1.2.1.1.7.1.1.3.11]
b. 1783 d. 12 Feb 1852
9
Hulda Kelley
[1.2.1.1.7.1.1.3.12]
b. 1 Mar 1785 d. 29 Mar 1785
9
David Kelly
[1.2.1.1.7.1.1.3.13]
b. 1786
8
Azor Daniels
[1.2.1.1.7.1.1.4]
b. 20 Feb 1743 d. 19 Sep 1748
8
Chloe Daniels
[1.2.1.1.7.1.1.5]
b. 13 Sep 1745 d. 19 May 1823
Seth Davenport
b. 2 Nov 1739 d. 28 Mar 1813
9
Anna Davenport
[1.2.1.1.7.1.1.5.1]
b. 8 Sep 1765 d. 1 Aug 1842
William Torrey
b. 23 Nov 1754 d. 16 Sep 1817
10
Samuel Davenport Torrey
[1.2.1.1.7.1.1.5.1.1]
b. 14 Apr 1789 d. 23 Dec 1877
Susan Holman Waters
b. 4 Apr 1803 d. 3 Feb 1866
11
Delia Chapin Torrey
[1.2.1.1.7.1.1.5.1.1.1]
b. 30 Sep 1825 d. 23 Feb 1919
11
Louisa Maria Torrey
[1.2.1.1.7.1.1.5.1.1.2]
b. 11 Sep 1827 d. 8 Dec 1907
Alphonso Taft
b. 5 Nov 1810 d. 21 May 1891
12
Samuel Davenport Taft
[1.2.1.1.7.1.1.5.1.1.2.1]
b. 7 Feb 1855 d. 1855
12
President William Howard Taft
[1.2.1.1.7.1.1.5.1.1.2.2]
b. 15 Sep 1857 d. 8 Mar 1930 [
=>
]
12
Henry Waters Taft
[1.2.1.1.7.1.1.5.1.1.2.3]
b. 27 May 1859 d. 11 Aug 1945 [
=>
]
12
Horace Dutton Taft
[1.2.1.1.7.1.1.5.1.1.2.4]
b. 28 Sep 1861 d. 28 Jan 1943
12
Alphonso Taft
[1.2.1.1.7.1.1.5.1.1.2.5]
b. 1865
12
Frances Louise Taft
[1.2.1.1.7.1.1.5.1.1.2.6]
b. 18 Jul 1865 d. 4 Jan 1950
11
Samuel Davenport Torrey
[1.2.1.1.7.1.1.5.1.1.3]
b. 10 Jan 1830 d. Aug 1830
11
Susan Waters Torrey
[1.2.1.1.7.1.1.5.1.1.4]
b. 26 Aug 1835 d. 1 Feb 1904
Samuel Austin Wood
b. Abt 1831
12
William Forristal Wood
[1.2.1.1.7.1.1.5.1.1.4.1]
b. 7 Apr 1865
12
Nellie Susie Wood
[1.2.1.1.7.1.1.5.1.1.4.2]
b. 1867
12
Samuel Austin Wood, Jr
[1.2.1.1.7.1.1.5.1.1.4.3]
b. 19 Feb 1869 [
=>
]
11
Anna Davenport Torrey
[1.2.1.1.7.1.1.5.1.1.5]
b. 1 Nov 1840 d. 23 Jun 1900
Edward Orton
b. 9 Mar 1829 d. 16 Oct 1899
12
Louise Taft Orton
[1.2.1.1.7.1.1.5.1.1.5.1]
b. 6 Jun 1877 [
=>
]
12
Samuel Torrey Orton
[1.2.1.1.7.1.1.5.1.1.5.2]
b. 15 Oct 1879
10
Joseph Torrey
[1.2.1.1.7.1.1.5.1.2]
b. 4 Oct 1790 d. 15 Nov 1836
Deborah Tuttle
b. 1795 d. 25 Jan 1844
11
Joseph Vinton Torrey
[1.2.1.1.7.1.1.5.1.2.1]
b. 4 Jan 1828
+
Harriet A Hudson
b. 1844
11
Eliza Ann Torrey
[1.2.1.1.7.1.1.5.1.2.2]
b. 12 Jan 1829
+
Richard K Morey
10
Louisa Torrey
[1.2.1.1.7.1.1.5.1.3]
b. 29 Mar 1792 d. 10 Jul 1874
10
Benjamin Torrey
[1.2.1.1.7.1.1.5.1.4]
b. 5 Mar 1794 d. 20 Oct 1797
10
Stephen Torrey
[1.2.1.1.7.1.1.5.1.5]
b. 25 Mar 1796 d. 29 Apr 1875
10
Benjamin Davenport Torrey
[1.2.1.1.7.1.1.5.1.6]
b. 19 Dec 1803 d. 24 Jun 1826
10
George Washington Torrey
[1.2.1.1.7.1.1.5.1.7]
b. 26 Oct 1806 d. 3 Oct 1885
Sabra Brown
b. 1807 d. 15 Jul 1889
11
Caroline Augusta Torrey
[1.2.1.1.7.1.1.5.1.7.1]
b. 5 Dec 1841 d. 22 Aug 1915
Henry Frank Martin
b. 18 Oct 1841 d. 30 Dec 1900
12
Louisa Repplier Martin
[1.2.1.1.7.1.1.5.1.7.1.1]
b. 20 May 1866
12
Annie Torrey Martin
[1.2.1.1.7.1.1.5.1.7.1.2]
b. 12 Sep 1867 [
=>
]
12
Henry Chauncey Martin
[1.2.1.1.7.1.1.5.1.7.1.3]
b. 16 Mar 1877
11
George Washington Torrey
[1.2.1.1.7.1.1.5.1.7.2]
b. 7 Mar 1844 d. 29 Jul 1903
+
Julia Brockway
11
Annie Davenport Torrey
[1.2.1.1.7.1.1.5.1.7.3]
b. Abt 1846 d. Bef 1929
Eugene Herbert Ingalls
b. 1 May 1850 d. 10 Nov 1900
12
Annie Davenport Ingalls
[1.2.1.1.7.1.1.5.1.7.3.1]
b. 24 Feb 1875
12
George Torrey Ingalls
[1.2.1.1.7.1.1.5.1.7.3.2]
b. 6 Dec 1876
12
Charles Edward Ingalls
[1.2.1.1.7.1.1.5.1.7.3.3]
b. 14 Sep 1878 d. Jul 1913
12
Horatio Houghton Ingalls
[1.2.1.1.7.1.1.5.1.7.3.4]
b. 27 May 1880 d. 6 Jan 1900
12
Louisa Steele Ingalls
[1.2.1.1.7.1.1.5.1.7.3.5]
b. 13 Jan 1883
12
Winslow Lewis Ingalls
[1.2.1.1.7.1.1.5.1.7.3.6]
b. 8 Oct 1884 d. Feb 1912
12
Kenneth Ingalls
[1.2.1.1.7.1.1.5.1.7.3.7]
b. 26 Mar 1888 d. Apr 1890
11
Harriet Oliver Torrey
[1.2.1.1.7.1.1.5.1.7.4]
b. 5 Oct 1849 d. 26 Nov 1850
11
William Torrey
[1.2.1.1.7.1.1.5.1.7.5]
b. 8 Dec 1851 d. 18 Dec 1881
11
Maria Torrey
[1.2.1.1.7.1.1.5.1.7.6]
b. 30 Jun 1854 d. 21 Jul 1855
11
Louise Torrey
[1.2.1.1.7.1.1.5.1.7.7]
b. 7 Aug 1856
11
Charles Torrey
[1.2.1.1.7.1.1.5.1.7.8]
b. 6 Jul 1859
Sarah Louise Mayo
b. 13 Mar 1861
12
Stephen Mayo Torrey
[1.2.1.1.7.1.1.5.1.7.8.1]
b. 10 Apr 1887
12
Ralph Martin Torrey
[1.2.1.1.7.1.1.5.1.7.8.2]
b. 25 Nov 1888
12
Madelaine Torrey
[1.2.1.1.7.1.1.5.1.7.8.3]
b. 25 Jul 1892 d. 3 Jul 1919
11
Eleanor Torrey
[1.2.1.1.7.1.1.5.1.7.9]
b. 13 Nov 1862
John Avery Potter
b. 18 Feb 1858
12
Elden Potter
[1.2.1.1.7.1.1.5.1.7.9.1]
b. 16 Jun 1893 d. 30 Dec 1897
12
Helen Frances Potter
[1.2.1.1.7.1.1.5.1.7.9.2]
b. 30 Mar 1895
+
Peter Holbrook
9
David Davenport
[1.2.1.1.7.1.1.5.2]
b. 17 Jan 1767
9
Mary Davenport
[1.2.1.1.7.1.1.5.3]
b. 30 Sep 1768
9
Rebecca Davenport
[1.2.1.1.7.1.1.5.4]
b. 9 Apr 1770 d. 15 May 1794
9
Samuel Daniels Davenport
[1.2.1.1.7.1.1.5.5]
b. 14 Oct 1772 d. 13 Feb 1802
9
Chloe Davenport
[1.2.1.1.7.1.1.5.6]
b. 23 Mar 1774 d. 5 Mar 1808
9
Seth Davenport
[1.2.1.1.7.1.1.5.7]
b. 13 Jan 1775 d. 22 Apr 1843
9
Benjamin Davenport
[1.2.1.1.7.1.1.5.8]
b. 10 Jul 1780 d. 14 Jul 1862
8
Matilda Daniels
[1.2.1.1.7.1.1.6]
b. 16 Sep 1747
John Gould
b. Abt 1758
9
Mary Gould
[1.2.1.1.7.1.1.6.1]
b. 1779 d. 27 May 1854
8
David Daniels
[1.2.1.1.7.1.1.7]
b. 10 Nov 1749 d. 30 Apr 1811
+
Olive Adams
b. 1 Jan 1755 d. 16 Sep 1832
8
Huldah Daniels
[1.2.1.1.7.1.1.8]
b. 6 Jan 1752 d. 26 Jun 1836
Silas Penniman
b. 20 Aug 1751 d. 12 May 1777
9
Scammell Penniman
[1.2.1.1.7.1.1.8.1]
b. 12 Oct 1772
9
Rhene Penniman
[1.2.1.1.7.1.1.8.2]
b. 27 Jan 1774
9
Amos Penniman
[1.2.1.1.7.1.1.8.3]
b. 9 Oct 1775
9
Silas Penniman
[1.2.1.1.7.1.1.8.4]
b. 12 Aug 1777 d. 1820
Henry Dearth
b. 6 Jun 1741 d. 24 Jun 1804
9
Ruth Dearth
[1.2.1.1.7.1.1.8.5]
b. 13 Jul 1787
9
Irene Dearth
[1.2.1.1.7.1.1.8.6]
b. 7 Apr 1789
9
June Dearth
[1.2.1.1.7.1.1.8.7]
b. 7 Apr 1789
9
Leonard Dearth
[1.2.1.1.7.1.1.8.8]
b. 30 Oct 1791 d. 3 Feb 1880
9
Mercy Dearth
[1.2.1.1.7.1.1.8.9]
b. 10 Sep 1793
8
Moses Daniels
[1.2.1.1.7.1.1.9]
b. 25 Feb 1753
Abigail Aldrich
b. 25 Feb 1761 d. 5 Jul 1834
9
Cyrena Daniels
[1.2.1.1.7.1.1.9.1]
b. 26 Sep 1782
9
Salley Daniels
[1.2.1.1.7.1.1.9.2]
b. 27 Nov 1784 d. 6 Sep 1842
9
Abigail Daniels
[1.2.1.1.7.1.1.9.3]
b. 15 Nov 1786
9
Elbridge C Daniels
[1.2.1.1.7.1.1.9.4]
b. 28 Nov 1788
9
Kelly Daniels
[1.2.1.1.7.1.1.9.5]
b. 23 Sep 1791 d. 30 Dec 1839
8
Clotilda Daniels
[1.2.1.1.7.1.1.10]
b. 19 Sep 1755 d. Abt 1813
Sherebiah Baker
b. 18 Mar 1747 d. May 1823
9
Marshal Baker
[1.2.1.1.7.1.1.10.1]
b. 8 Nov 1774 d. 20 Oct 1848
9
Phila Baker
[1.2.1.1.7.1.1.10.2]
b. 10 Jul 1773
9
Marshall Baker
[1.2.1.1.7.1.1.10.3]
b. 1779
7
Priscilla Taft
[1.2.1.1.7.1.2]
b. 15 Aug 1721 d. Jan 1760
Moses Wood
b. 3 Apr 1712 d. Apr 1780
8
Mary Wood
[1.2.1.1.7.1.2.1]
b. 3 Mar 1740 d. 17 Apr 1841
8
Prissella Wood
[1.2.1.1.7.1.2.2]
b. 18 May 1741 d. 18 May 1741
8
Jerusha Wood
[1.2.1.1.7.1.2.3]
b. Abt 1744 d. 27 Apr 1790
8
Rachel Wood
[1.2.1.1.7.1.2.4]
b. 9 Jun 1746
8
Moses Wood
[1.2.1.1.7.1.2.5]
b. Abt 1748
8
Susanna Wood
[1.2.1.1.7.1.2.6]
b. Abt 1748
8
Daniel Wood
[1.2.1.1.7.1.2.7]
b. 10 Mar 1757
8
Hezekiah Wood
[1.2.1.1.7.1.2.8]
b. 14 Jan 1760 d. 26 May 1811
8
Rhoda Wood
[1.2.1.1.7.1.2.9]
b. 13 Apr 1762
7
Israel Taft
[1.2.1.1.7.1.3]
b. 23 Apr 1723 d. 1775
Martha Smith
b. 1722
8
Israel Taft
[1.2.1.1.7.1.3.1]
b. 12 Dec 1743
8
Amariah Taft
[1.2.1.1.7.1.3.2]
b. 18 Apr 1746 d. 1770
8
Oliver Taft
[1.2.1.1.7.1.3.3]
b. 4 Feb 1750
8
Elizabeth Taft
[1.2.1.1.7.1.3.4]
b. 27 Jul 1753
8
Marce Taft
[1.2.1.1.7.1.3.5]
b. 16 Jan 1757
7
Jacob Taft
[1.2.1.1.7.1.4]
b. 22 Apr 1725 d. 15 Mar 1802
Esther Marsh
b. 28 Jun 1726 d. 14 Mar 1802
8
Esther Taft
[1.2.1.1.7.1.4.1]
b. 9 Jan 1747 d. 3 Feb 1834
James Taft
b. 9 Apr 1738 d. 14 Jan 1826
9
Lucy Taft
[1.2.1.1.7.1.4.1.1]
b. 22 Nov 1769 d. 29 Jul 1845
Ebenezer Winslow
b. 21 Jan 1772 d. 21 Feb 1841
10
Albert Winslow
[1.2.1.1.7.1.4.1.1.1]
b. 24 Jul 1797
Sarah Gardner
b. 25 Jul 1803 d. 23 Sep 1840
11
Martha Maria Winslow
[1.2.1.1.7.1.4.1.1.1.1]
b. 12 Mar 1826 d. 16 Mar 1842
11
Preston Willard Winslow
[1.2.1.1.7.1.4.1.1.1.2]
b. 13 Nov 1828
Lucy Weatherbee
b. 16 Jul 1829 d. 8 Nov 1859
12
Mary Charlena Winslow
[1.2.1.1.7.1.4.1.1.1.2.1]
b. 22 Apr 1858
+
Maria Fuller
b. 12 Apr 1841
11
Mary Augusta Allen Winslow
[1.2.1.1.7.1.4.1.1.1.3]
b. 14 Sep 1831
+
Charles Warner
b. Abt 1830
11
John Alvin Winslow
[1.2.1.1.7.1.4.1.1.1.4]
b. 3 Jul 1834
11
Jasper Ross Winslow
[1.2.1.1.7.1.4.1.1.1.5]
b. 7 Apr 1837 d. 25 Oct 1841
11
Sarah Adaline Winslow
[1.2.1.1.7.1.4.1.1.1.6]
b. 20 Dec 1839 d. 9 Dec 1841
Sylvia Babbit
b. 27 Jan 1814
11
Jasper Albert Winslow
[1.2.1.1.7.1.4.1.1.1.7]
b. 15 Apr 1842 d. 14 Oct 1864
10
Claramond Winslow
[1.2.1.1.7.1.4.1.1.2]
b. 10 Feb 1799 d. 27 Apr 1834
John Hathaway
b. 22 May 1797
11
Son Hathaway
[1.2.1.1.7.1.4.1.1.2.1]
b. Apr 1828 d. 14 Apr 1828
11
Francis Ebenezer Hathaway
[1.2.1.1.7.1.4.1.1.2.2]
b. 9 Mar 1829
Lydia Carter
b. 24 Mar 1832
12
Hattie Carter Hathaway
[1.2.1.1.7.1.4.1.1.2.2.1]
b. 10 Jan 1865 d. 30 Oct 1958 [
=>
]
11
Catherine Elizabeth Hathaway
[1.2.1.1.7.1.4.1.1.2.3]
b. 18 Feb 1833
11
George H Hathaway
[1.2.1.1.7.1.4.1.1.2.4]
b. 13 Aug 1839
Abigail F Pomeroy
b. Abt 1843 d. 9 Feb 1891
12
Charles Edward Hathaway
[1.2.1.1.7.1.4.1.1.2.4.1]
b. 23 Oct 1866
10
Alvin Winslow
[1.2.1.1.7.1.4.1.1.3]
b. 27 Aug 1802 d. 9 Oct 1803
10
Paulina Maria Winslow
[1.2.1.1.7.1.4.1.1.4]
b. 27 May 1805
+
Austin Crosby
b. 10 Mar 1805 d. 13 Jun 1868
10
Lucy Emma Winslow
[1.2.1.1.7.1.4.1.1.5]
b. 17 Feb 1808 d. 20 Feb 1870
+
Matthew Henry McClary
b. 10 Mar 1801
9
Zilpha Taft
[1.2.1.1.7.1.4.1.2]
b. 1 Jul 1772 d. 24 Feb 1848
Nathan Fisher
b. 25 Jun 1770 d. 21 Mar 1847
10
Elias Fisher
[1.2.1.1.7.1.4.1.2.1]
b. 10 Jul 1796
10
Elise Fisher
[1.2.1.1.7.1.4.1.2.2]
b. 10 Jul 1796
10
Josiah Fisher
[1.2.1.1.7.1.4.1.2.3]
b. 26 Feb 1798 d. 11 Apr 1799
10
Josiah Fisher
[1.2.1.1.7.1.4.1.2.4]
b. 1 Dec 1801
10
Rachel Adaline Fisher
[1.2.1.1.7.1.4.1.2.5]
b. 29 Jan 1804
+
Moses Daniels Southwick
10
Mary Caroline Fisher
[1.2.1.1.7.1.4.1.2.6]
b. 22 Mar 1806
10
Nathan Fisher
[1.2.1.1.7.1.4.1.2.7]
b. 21 Mar 1811
9
Irena Taft
[1.2.1.1.7.1.4.1.3]
b. 25 Oct 1774 d. 29 May 1790
9
Ezekial Taft
[1.2.1.1.7.1.4.1.4]
b. 21 Jan 1777 d. 24 Apr 1841
+
Olive Thayer
b. 10 Aug 1782 d. 1865
9
James Taft
[1.2.1.1.7.1.4.1.5]
b. 13 Jun 1780
9
Luke Taft
[1.2.1.1.7.1.4.1.6]
b. 3 Jun 1783
Nancy Wood
b. 6 Feb 1787 d. 6 May 1859
10
Clarissa Wood Taft
[1.2.1.1.7.1.4.1.6.1]
b. 3 May 1810 d. 1889
Caleb Chapin
b. 6 Feb 1806 d. 27 Sep 1883
11
Eunice Chapin
[1.2.1.1.7.1.4.1.6.1.1]
b. 1 May 1832 d. 29 Sep 1920
Samuel Mills Capron
b. 15 May 1832 d. 4 Jan 1874
12
Helen Maria Capron
[1.2.1.1.7.1.4.1.6.1.1.1]
b. 26 Mar 1858 d. 6 Jan 1863
12
Alice Louise Capron
[1.2.1.1.7.1.4.1.6.1.1.2]
b. 26 Mar 1862 d. 13 Jan 1863
12
Clara D Capron
[1.2.1.1.7.1.4.1.6.1.1.3]
b. 4 Aug 1864
12
Bertha C Capron
[1.2.1.1.7.1.4.1.6.1.1.4]
b. 16 Mar 1868 [
=>
]
12
William Cargill Capron
[1.2.1.1.7.1.4.1.6.1.1.5]
b. 27 Jul 1869 [
=>
]
11
Ezra Wood Chapin
[1.2.1.1.7.1.4.1.6.1.2]
b. 7 Jun 1836 d. 31 Mar 1909
Ellen Frances Cooper
b. 30 Dec 1835
12
Janet Chapin
[1.2.1.1.7.1.4.1.6.1.2.1]
b. 28 May 1870
11
Edwin Chapin
[1.2.1.1.7.1.4.1.6.1.3]
b. 7 Jun 1836 d. 27 Sep 1836
10
Moses Taft
[1.2.1.1.7.1.4.1.6.2]
b. 26 Jan 1812
Sylvia Ann Wheelock
b. 3 Feb 1815 d. 3 Oct 1855
11
Sarah Wood Taft
[1.2.1.1.7.1.4.1.6.2.1]
b. 6 Jan 1838
Lewis Henry Murdock
b. 17 Mar 1835 d. 25 Mar 1916
12
Herbert Taft Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.6.2.1.1]
b. 11 Sep 1865 d. 29 Oct 1916 [
=>
]
12
Edgar Wheelock Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.6.2.1.2]
b. 1 Feb 1869 d. 13 Jun 1904
11
Susan Hortense Taft
[1.2.1.1.7.1.4.1.6.2.2]
b. 5 Jan 1843
11
Luke Herbert Taft
[1.2.1.1.7.1.4.1.6.2.3]
b. 9 Nov 1846
+
Helen Eugenia Bechet
10
Sarah Taft
[1.2.1.1.7.1.4.1.6.3]
b. 15 Jan 1815 d. 24 Dec 1898
Amariah Albee Wood
b. 2 Nov 1802 d. 14 Jun 1871
11
Sarah A Wood
[1.2.1.1.7.1.4.1.6.3.1]
b. May 1837 d. 26 Sep 1837
11
Samuel Taft Wood
[1.2.1.1.7.1.4.1.6.3.2]
b. 4 Oct 1841 d. Jun 1925
+
Olive DeWilton Seagrave
b. 17 Jul 1842 d. 7 Aug 1862
Mary E Rawson
b. 11 Sep 1845
12
Eva Gertrude Wood
[1.2.1.1.7.1.4.1.6.3.2.1]
b. 29 May 1865
12
Merritt D Wood
[1.2.1.1.7.1.4.1.6.3.2.2]
b. 2 Sep 1873
11
Mary Baylies Wood
[1.2.1.1.7.1.4.1.6.3.3]
b. 29 Apr 1847 d. 9 Sep 1847
11
Anna I Wood
[1.2.1.1.7.1.4.1.6.3.4]
b. 18 Aug 1848 d. 1919
10
Irene Taft
[1.2.1.1.7.1.4.1.6.4]
b. 19 Sep 1816 d. 26 Jan 1900
Silas Mandeville Wheelock
b. 11 Nov 1817 d. 18 Oct 1901
11
Ellen Maria Wheelock
[1.2.1.1.7.1.4.1.6.4.1]
b. 2 Sep 1842 d. 1871
11
Eugene Augustus Wheelock
[1.2.1.1.7.1.4.1.6.4.2]
b. 15 Feb 1846 d. 14 Sep 1912
Sarah Smith Taft
b. 17 Apr 1846
12
Silas Mandeville Wheelock
[1.2.1.1.7.1.4.1.6.4.2.1]
b. 10 Mar 1871 d. 22 Jun 1937 [
=>
]
12
Ellen Maria Wheelock
[1.2.1.1.7.1.4.1.6.4.2.2]
b. 20 Mar 1873 d. 12 Mar 1954
12
Mary Taft Wheelock
[1.2.1.1.7.1.4.1.6.4.2.3]
b. 8 Aug 1875 d. 21 Jul 1957
12
Irene Taft Wheelock
[1.2.1.1.7.1.4.1.6.4.2.4]
b. 7 Apr 1881 d. 2 Jan 1963
12
Henry Arnold Wheelock
[1.2.1.1.7.1.4.1.6.4.2.5]
b. 27 Aug 1883 d. 12 Jul 1954
+
Caroline Harper
11
Alice Augusta Wheelock
[1.2.1.1.7.1.4.1.6.4.3]
b. 22 Jan 1849 d. Sep 1891
11
Arthur Wheelock
[1.2.1.1.7.1.4.1.6.4.4]
b. 26 Mar 1851 d. 23 Sep 1927
Emogene Atchinson
b. 22 Sep 1851 d. 12 Apr 1898
12
Stanley H Wheelock
[1.2.1.1.7.1.4.1.6.4.4.1]
b. 15 Jul 1879 [
=>
]
12
Annie Atchinan Wheelock
[1.2.1.1.7.1.4.1.6.4.4.2]
b. 15 Jan 1887 d. 5 Oct 1918
+
Harriet E Fuller
b. 1845
11
Henry Wheelock
[1.2.1.1.7.1.4.1.6.4.5]
b. 14 Jan 1857 d. 13 Nov 1881
+
Jane Goulding Taft
b. 12 Oct 1856 d. 20 Jan 1931
10
Chloe M Taft
[1.2.1.1.7.1.4.1.6.5]
b. 5 Feb 1823
Luke Southwick Farnham
b. 20 Jan 1817 d. 23 Aug 1883
11
Elizabeth Southwick Farnham
[1.2.1.1.7.1.4.1.6.5.1]
b. 1852
+
Jerome Prentiss
11
Ella Frances Farnham
[1.2.1.1.7.1.4.1.6.5.2]
b. 1855
11
Moses Taft Farnham
[1.2.1.1.7.1.4.1.6.5.3]
b. 1858
11
Walter James Farnham
[1.2.1.1.7.1.4.1.6.5.4]
b. 1862
10
James Taft
[1.2.1.1.7.1.4.1.6.6]
b. 1830
9
Esther Taft
[1.2.1.1.7.1.4.1.7]
b. 5 Aug 1786 d. 10 Aug 1858
Fuller Murdock
b. 17 Feb 1781 d. 8 Nov 1857
10
Philena Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.1]
b. 26 Aug 1807 d. 30 Jun 1835
Samuel Merriam
b. Abt 1803
11
George Nison Merriam
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.1.1]
b. 26 Dec 1834 d. 19 Nov 1903
Ellen Jane Pickering
b. 27 Mar 1836 d. 15 Jan 1911
12
Josephine Louisa Merriam
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.1.1.1]
b. 29 Oct 1859 d. 14 Mar 1949
12
Nellie Pickering Merriam
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.1.1.2]
b. 26 Feb 1870 d. 20 Nov 1887
12
Flora N. Merriam
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.1.1.3]
b. 31 Mar 1872
10
Abba Eliza Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.2]
b. 13 Nov 1808 d. 4 Apr 1834
Pemberton Brown
b. 11 Oct 1801 d. 30 Mar 1870
11
Tarissa Gregory Brown
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.2.1]
b. 3 Oct 1828 d. 12 Oct 1914
John Conley Fisher
b. 25 May 1818 d. 1 Dec 1898
12
Paulina Agnes Fisher
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.2.1.1]
b. 2 Dec 1848 d. 2 Oct 1850
12
Elizabeth B Fisher
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.2.1.2]
b. 25 Jun 1853 d. 5 Nov 1933 [
=>
]
12
Alonzo Pemberton Fisher
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.2.1.3]
b. 11 Dec 1855 d. 21 Feb 1937 [
=>
]
12
Ida H. Fisher
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.2.1.4]
b. 1858
12
Lillian L. Fisher
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.2.1.5]
b. 2 Oct 1860
12
Malvern Adelbert Fisher
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.2.1.6]
b. 30 Mar 1863 [
=>
]
12
Georgene Fisher Gardner
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.2.1.7]
b. 12 Oct 1864 d. 17 Oct 1942 [
=>
]
12
Myrtella Fisher
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.2.1.8]
b. 30 Jul 1867
11
Josephine Brown
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.2.2]
b. 29 Jan 1830 d. 16 Jan 1895
William Brainerd Cadwell
b. 2 Sep 1832 d. 1870
12
Abbie Flora Cadwell
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.2.2.1]
b. 19 Oct 1854 d. 24 Sep 1937 [
=>
]
12
Etola Florence Cadwell
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.2.2.2]
b. 16 Jul 1857 d. 27 Dec 1937 [
=>
]
11
Adin Ballou Brown
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.2.3]
b. 14 Nov 1831 d. 19 Apr 1880
11
Edin Ballow Brown
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.2.4]
b. 14 Nov 1831
11
Abba Eliza Brown
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.2.5]
b. 30 Jun 1833 d. 19 Oct 1914
Abiel Copelin
b. 22 Jul 1834 d. 8 Jul 1907
12
Arthur A. Copelin
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.2.5.1]
b. 1859 d. 3 May 1884
12
Herbert A. Copelin
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.2.5.2]
b. 31 May 1867 d. 14 Aug 1867
10
Moses Taft Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.3]
b. 12 Sep 1810 d. 7 Feb 1883
Dorinda Wood Grout
b. 19 Aug 1810 d. 15 Jan 1888
11
Cyrus Grout Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.3.1]
b. 16 Jun 1833 d. 7 Jun 1913
Sarah Ann Aldrich
b. 3 Apr 1831 d. 1 Mar 1902
12
Son Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.3.1.1]
b. 20 May 1856 d. 20 May 1856
12
Lillian A Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.3.1.2]
b. 17 Apr 1857 d. 7 Dec 1927
12
Bertha Aldrich Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.3.1.3]
b. 15 May 1872 d. 12 Nov 1940
11
Lewis Henry Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.3.2]
b. 17 Mar 1835 d. 25 Mar 1916
Sarah Wood Taft
b. 6 Jan 1838
12
Herbert Taft Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.3.2.1]
b. 11 Sep 1865 d. 29 Oct 1916 [
=>
]
12
Edgar Wheelock Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.3.2.2]
b. 1 Feb 1869 d. 13 Jun 1904
11
Sarah A Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.3.3]
b. Jul 1837 d. 1 Sep 1838
11
Lucius Walter Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.3.4]
b. 11 Apr 1846 d. 1 Jul 1867
11
Samuel Justin Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.3.5]
b. 13 May 1848 d. 11 May 1910
Mary Brown
b. 1843 d. 11 Apr 1920
12
Lena D M Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.3.5.1]
b. 5 Mar 1871 d. 30 Jun 1871
12
Lewis F Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.3.5.2]
b. 18 May 1873
11
Lyman Wood Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.3.6]
b. 26 Dec 1853 d. Bef 1900
Elizabeth Ann Snowling
b. 16 Jan 1860 d. 17 Aug 1918
12
May A. Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.3.6.1]
b. 1881
12
Minnie Idella Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.3.6.2]
b. 19 Jun 1884
10
John Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.4]
b. 9 Sep 1812 d. 13 Sep 1837
10
Charles Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.5]
b. 11 Feb 1815 d. 6 Aug 1869
Mary Ann Weightman
b. 3 Apr 1823 d. 11 May 1895
11
Charles W Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.5.1]
b. 4 Mar 1854 d. 5 Mar 1916
Abba Loretta Wardwell
b. 29 Jan 1849 d. 12 Jun 1929
12
Leroy Eugene Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.5.1.1]
b. 22 Jan 1875 [
=>
]
12
Horace Sherman Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.5.1.2]
b. 27 May 1879 [
=>
]
10
Caleb Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.6]
b. 16 Feb 1817 d. 10 May 1892
Maria Howard Emerson
b. 27 Dec 1830 d. 11 Oct 1901
11
Frank Fuller Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.6.1]
b. 18 May 1857 d. 13 Jan 1939
Alice M Gardner
b. Apr 1868
12
Dorothy Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.6.1.1]
b. 27 Nov 1892 d. Jul 1978
12
Edwin Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.6.1.2]
b. 11 Jun 1896 d. Jun 1977
11
Herbert Emerson Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.6.2]
b. 16 Jan 1859 d. 18 Jan 1931
Nancy Sophia Brigham
b. 29 Sep 1862 d. 1 Mar 1943
12
Russell Brigham Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.6.2.1]
b. 7 Sep 1893 d. 20 Feb 1969
12
Phyllis Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.6.2.2]
b. 15 Nov 1895
12
Marjory Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.6.2.3]
b. 1896
11
Eugene Clifford Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.6.3]
b. 24 Nov 1863 d. 13 Sep 1924
+
Elizabeth Howland Hutchinson
b. 7 Dec 1856
11
Carrie Maria Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.6.4]
b. 4 Sep 1865
Edward Augustus Rich
b. 29 Jul 1844 d. Bef 1930
12
Priscilla Augusta Rich
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.6.4.1]
b. 19 Oct 1898 d. 13 Apr 1899
12
Edward Augustus Rich
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.6.4.2]
b. 19 May 1900 d. 2 Nov 1982
10
George Taft Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.7]
b. 18 Mar 1819
Abbie Ann Robinson
b. Abt 1825
11
George Thurston Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.7.1]
b. 4 Jul 1846 d. 30 Jan 1933
Arvilla Richardson Thayer
b. 4 Feb 1850 d. 29 Oct 1902
12
Mabel Florence Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.7.1.1]
b. 13 Dec 1875 d. Aft 1944 [
=>
]
11
Lizzie Green Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.7.2]
b. 2 Sep 1857 d. 3 May 1879
Horace Edward Bigelow
b. 9 Jun 1857
12
Daughter Bigelow
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.7.2.1]
b. 1879
12
Geraldine Murdock Bigelow
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.7.2.2]
b. 16 Apr 1879
12
Gretchen M. Bigelow
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.7.2.3]
b. 1880 [
=>
]
10
Harriet E. Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.8]
b. 6 Feb 1821 d. 30 Nov 1904
David Franum Wood
b. 16 Feb 1818 d. 4 Feb 1896
11
Arthur Eugene Wood
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.8.1]
b. 20 Jan 1844 d. 20 Apr 1920
Clara Hubbard Wood
b. Dec 1848
12
Alice Marion Wood
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.8.1.1]
b. 20 Nov 1872 d. 16 Sep 1897
11
Hattie Esther Wood
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.8.2]
b. 5 Aug 1855
Walter M Farwell
b. 1852 d. 13 Apr 1910
12
Laurence Wood Farwell
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.8.2.1]
b. 14 Sep 1885 d. Jan 1965
10
Chapin Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.9]
b. 20 Jun 1823 d. 17 Sep 1882
Julia A Smith
b. 1824 d. 21 Jun 1909
11
Luther Oscar Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.9.1]
b. 6 Oct 1848 d. 1 Nov 1904
Harriet Flora Huntress
b. 13 Nov 1850 d. 14 Mar 1935
12
Minnie Uranah Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.9.1.1]
b. 8 Aug 1872 d. 22 Sep 1872
12
Oscar Eugene Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.9.1.2]
b. 7 Jul 1876 d. 24 Jan 1912 [
=>
]
12
Walter Ernest Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.9.1.3]
b. 16 Jan 1879 d. 1 Feb 1896
12
Alice Evaline Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.9.1.4]
b. 10 Jul 1881 d. 12 Jun 1923 [
=>
]
12
George Luther Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.9.1.5]
b. 21 Mar 1887
12
Arthur Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.9.1.6]
b. 18 Jul 1889
11
Loren Nelson Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.9.2]
b. 3 Jul 1850 d. 11 May 1923
Eda Annella Robinson
b. 10 Aug 1862 d. 1932
12
Morton I Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.9.2.1]
b. 12 Nov 1889 d. 20 Mar 1933
11
Eldoras Filasker Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.9.3]
b. 18 Jun 1852
Jane Maxwell
b. Dec 1852 d. 3 Nov 1935
12
Minnie Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.9.3.1]
b. 13 Aug 1875 d. 12 Feb 1946 [
=>
]
12
William Henry Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.9.3.2]
b. 29 Oct 1877
11
William Fuller Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.9.4]
b. 19 Jun 1855 d. 26 Nov 1924
Maria Sophia Giles
b. 13 Jul 1857 d. 9 Nov 1940
12
Lilla Gertrude Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.9.4.1]
b. 20 Jun 1883 d. 24 Jan 1951 [
=>
]
12
Ada Emma Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.9.4.2]
b. 29 Nov 1885 d. 2 Jan 1950 [
=>
]
12
Cora May Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.9.4.3]
b. 7 Feb 1889 d. 1959
12
Mamie Giles Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.9.4.4]
b. 6 May 1892 d. 2 Apr 1896
11
Emma E Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.9.5]
b. 30 May 1857 d. 23 Jul 1913
Albertus D Matthewson
b. 29 Nov 1850 d. 19 Mar 1911
12
Frederick E Mathewson
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.9.5.1]
b. 23 Nov 1874
Aaron William Mason
b. 15 Aug 1847 d. 19 Mar 1904
12
William C Mason
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.9.5.2]
b. 14 Jul 1895 d. 16 Jul 1895
10
Mary Ann Murdock
[1.2.1.1.7.1.4.1.7.10]
b. 18 Jun 1825 d. 27 Aug 1834
9
Moses Taft
[1.2.1.1.7.1.4.1.8]
b. 14 Jul 1788 d. 26 Jun 1810
9
Abigail Taft
[1.2.1.1.7.1.4.1.9]
b. 24 Jan 1791 d. 15 May 1837
Chandler Taft
b. 29 May 1792
10
Augustine Calvin Taft
[1.2.1.1.7.1.4.1.9.1]
b. 11 May 1817
Deborah Millett Taylor
11
Alice Bradford Taft
[1.2.1.1.7.1.4.1.9.1.1]
b. 26 Oct 1841
11
Edward A Taft
[1.2.1.1.7.1.4.1.9.1.2]
b. 8 Apr 1845
8
Timothy Taft
[1.2.1.1.7.1.4.2]
b. 3 Apr 1750 d. 30 Nov 1808
Priscilla Taft
b. 30 Apr 1749 d. 12 Sep 1833
9
Marcy Taft
[1.2.1.1.7.1.4.2.1]
b. 28 Sep 1771 d. 1 Aug 1848
+
Ezekiah Preston
b. Abt 1771
9
Josiah Taft
[1.2.1.1.7.1.4.2.2]
b. 3 May 1774
9
Abigail Taft
[1.2.1.1.7.1.4.2.3]
b. 14 Jan 1777 d. 17 Dec 1832
Moses Stone
b. 2 Mar 1775 d. 10 May 1803
10
Jonas Stone
[1.2.1.1.7.1.4.2.3.1]
b. 6 Jun 1795 d. 30 Sep 1795
10
Sukey Stone
[1.2.1.1.7.1.4.2.3.2]
b. 19 Feb 1798
9
Polly Taft
[1.2.1.1.7.1.4.2.4]
b. 1779 d. 5 Sep 1785
9
Timothy Taft
[1.2.1.1.7.1.4.2.5]
b. 1782 d. 5 Jan 1818
Mary "Polly" Reidel
b. 8 Feb 1784 d. 8 Feb 1863
10
Timothy Clark Taft
[1.2.1.1.7.1.4.2.5.1]
b. 21 Jul 1800 d. 11 May 1872
Mary A Hitchcock
b. 4 Jan 1802 d. 26 Oct 1842
11
Samuel Adams Taft
[1.2.1.1.7.1.4.2.5.1.1]
b. 11 Mar 1830 d. 5 Feb 1916
Jennie M Holt
b. 1841 d. 10 Feb 1882
12
Emma Julia Taft
[1.2.1.1.7.1.4.2.5.1.1.1]
b. 19 Jun 1865 d. 15 Jun 1929 [
=>
]
11
Elizabeth C Taft
[1.2.1.1.7.1.4.2.5.1.2]
b. 6 Jun 1834 d. 13 Dec 1915
Franklin E Hall
b. 15 Sep 1829 d. 3 Jun 1907
12
Elizabeth C Hall
[1.2.1.1.7.1.4.2.5.1.2.1]
b. 8 Jan 1855 [
=>
]
12
Frank Erwin Hall
[1.2.1.1.7.1.4.2.5.1.2.2]
b. 6 Dec 1861 d. 26 Dec 1943 [
=>
]
12
Edith Mabel Hall
[1.2.1.1.7.1.4.2.5.1.2.3]
b. 13 Apr 1870 d. 2 Aug 1952 [
=>
]
12
Gertrude Susan Hall
[1.2.1.1.7.1.4.2.5.1.2.4]
b. 26 Apr 1872 d. 6 Dec 1918 [
=>
]
10
Adolphus Taft
[1.2.1.1.7.1.4.2.5.2]
b. Abt 1804
10
Harry Taft
[1.2.1.1.7.1.4.2.5.3]
b. Abt 1806
10
Ezekiel Preston Taft
[1.2.1.1.7.1.4.2.5.4]
b. Abt 1807
10
Washington Taft
[1.2.1.1.7.1.4.2.5.5]
b. Abt 1808 d. Abt 1823
10
Charlotte Clark Taft
[1.2.1.1.7.1.4.2.5.6]
b. Abt 1810
+
Hyman Sage
b. Abt 1810
10
Christine Taft
[1.2.1.1.7.1.4.2.5.7]
b. 1811 d. 8 Jul 1847
+
George Heath
b. Abt 1811
10
Jacob R Taft
[1.2.1.1.7.1.4.2.5.8]
b. 29 Oct 1814 d. 1 Jan 1875
+
Caroline Cowles
b. 10 Jun 1817 d. 25 Jun 1875
9
Joseph Taft
[1.2.1.1.7.1.4.2.6]
b. 1784
9
Jonas Taft
[1.2.1.1.7.1.4.2.7]
b. 1786
9
Polly Taft
[1.2.1.1.7.1.4.2.8]
b. 1788 d. 1859
8
Jacob Taft
[1.2.1.1.7.1.4.3]
b. 1 Dec 1751 d. 30 May 1823
Mary Taft
b. 14 Feb 1753 d. 19 Jul 1832
9
Lois Taft
[1.2.1.1.7.1.4.3.1]
b. 27 Aug 1780 d. 27 Apr 1854
Josiah Seagrave
b. 14 Oct 1773 d. 20 Mar 1855
10
Mary Ann Seagrave
[1.2.1.1.7.1.4.3.1.1]
b. 17 Nov 1799 d. 10 Feb 1825
10
Jacob Taft Seagraves
[1.2.1.1.7.1.4.3.1.2]
b. 8 Apr 1802 d. 24 Sep 1870
10
Henrietta Frost Seagrave
[1.2.1.1.7.1.4.3.1.3]
b. 1 Dec 1803 d. 1 Jun 1823
10
Waity Grant Seagrave
[1.2.1.1.7.1.4.3.1.4]
b. 23 Sep 1805 d. 27 Jan 1859
10
Edward Seagrave
[1.2.1.1.7.1.4.3.1.5]
b. 3 Sep 1807 d. 15 Feb 1873
10
Lois Taft Seagrave
[1.2.1.1.7.1.4.3.1.6]
b. 13 Apr 1809 d. 19 Mar 1853
10
Josiah Seagrave, Jr
[1.2.1.1.7.1.4.3.1.7]
b. 24 May 1811 d. 21 Jul 1861
10
Malvina Seagrave
[1.2.1.1.7.1.4.3.1.8]
b. 2 Apr 1813 d. 16 Dec 1823
10
Caleb Seagrave
[1.2.1.1.7.1.4.3.1.9]
b. 8 Feb 1815 d. 14 Nov 1823
10
Son Seagrave
[1.2.1.1.7.1.4.3.1.10]
b. 3 May 1817 d. 3 May 1817
10
Daughter Seagrave
[1.2.1.1.7.1.4.3.1.11]
b. 3 May 1817 d. 3 May 1817
10
Esborn Seagrave
[1.2.1.1.7.1.4.3.1.12]
b. 28 Dec 1818 d. 27 Oct 1856
10
George Augustus Seagrave
[1.2.1.1.7.1.4.3.1.13]
b. 6 Jan 1823 d. 15 Nov 1884
9
Hannah Margaret Taft
[1.2.1.1.7.1.4.3.2]
b. 28 Nov 1782 d. 2 Apr 1857
Stephen Carpenter
b. 13 Aug 1778 d. 1 Oct 1854
10
Eunice Carpenter
[1.2.1.1.7.1.4.3.2.1]
b. Sep 1802 d. Mar 1864
10
Orsmus T Carpenter
[1.2.1.1.7.1.4.3.2.2]
b. Jan 1805 d. 4 Apr 1863
10
Joseph Rawson Carpenter
[1.2.1.1.7.1.4.3.2.3]
b. 2 Apr 1807 d. May 1839
10
Charlotte Taft Carpenter
[1.2.1.1.7.1.4.3.2.4]
b. 4 Feb 1809 d. 5 Sep 1845
10
Charles A Carpenter
[1.2.1.1.7.1.4.3.2.5]
b. 11 Feb 1813 d. 12 Aug 1887
10
Mary T Carpenter
[1.2.1.1.7.1.4.3.2.6]
b. 1815
10
Hannah Taft Carpenter
[1.2.1.1.7.1.4.3.2.7]
b. 20 Aug 1817 d. 17 Dec 1890
10
Nancy Carter Carpenter
[1.2.1.1.7.1.4.3.2.8]
b. 5 Jun 1820 d. 15 May 1898
10
Henrietta Carpenter
[1.2.1.1.7.1.4.3.2.9]
b. Apr 1823 d. Feb 1847
10
George Carpenter
[1.2.1.1.7.1.4.3.2.10]
b. 13 Jan 1825
9
Elisabeth Taft
[1.2.1.1.7.1.4.3.3]
b. 8 Nov 1784
Ephraim Taft
b. 18 Aug 1780
10
Mary Ann Taft
[1.2.1.1.7.1.4.3.3.1]
b. 22 May 1805
10
Ephriam Taft
[1.2.1.1.7.1.4.3.3.2]
b. 8 Feb 1807
9
Mary Taft
[1.2.1.1.7.1.4.3.4]
b. 16 Mar 1786 d. 25 Feb 1860
9
Charlotte Taft
[1.2.1.1.7.1.4.3.5]
b. 25 Feb 1789
9
John Taft
[1.2.1.1.7.1.4.3.6]
b. 3 Dec 1792 d. 29 May 1826
Lucretia Newell
b. 24 Sep 1795 d. 29 Dec 1863
10
Robert Taft
[1.2.1.1.7.1.4.3.6.1]
b. 27 May 1819
10
Jacob Taft
[1.2.1.1.7.1.4.3.6.2]
b. 19 May 1823
9
Orsmus Taft
[1.2.1.1.7.1.4.3.7]
b. 1 Jan 1795
8
Abigail Taft
[1.2.1.1.7.1.4.4]
b. 5 Oct 1754 d. 12 Aug 1775
Barzillai Taft
b. 3 Nov 1750 d. 21 Jan 1839
9
Eunice Taft
[1.2.1.1.7.1.4.4.1]
b. 28 Jan 1775 d. 30 May 1861
Phineas Chapin
b. 3 Aug 1769 d. 3 May 1839
10
Abby Chapin
[1.2.1.1.7.1.4.4.1.1]
b. 1 Feb 1796
10
Laurinda Chapin
[1.2.1.1.7.1.4.4.1.2]
b. 6 Feb 1798 d. 20 Dec 1866
10
Sarah Richardson Chapin
[1.2.1.1.7.1.4.4.1.3]
b. 30 Apr 1800 d. 16 Apr 1884
10
Chloe T Chapin
[1.2.1.1.7.1.4.4.1.4]
b. 8 Apr 1802 d. 5 Oct 1881
10
Mary Warren Chapin
[1.2.1.1.7.1.4.4.1.5]
b. 27 Feb 1804 d. 13 Nov 1890
10
Caleb Chapin
[1.2.1.1.7.1.4.4.1.6]
b. 6 Feb 1806 d. 27 Sep 1883
Clarissa Wood Taft
b. 3 May 1810 d. 1889
11
Eunice Chapin
[1.2.1.1.7.1.4.4.1.6.1]
b. 1 May 1832 d. 29 Sep 1920
Samuel Mills Capron
b. 15 May 1832 d. 4 Jan 1874
12
Helen Maria Capron
[1.2.1.1.7.1.4.4.1.6.1.1]
b. 26 Mar 1858 d. 6 Jan 1863
12
Alice Louise Capron
[1.2.1.1.7.1.4.4.1.6.1.2]
b. 26 Mar 1862 d. 13 Jan 1863
12
Clara D Capron
[1.2.1.1.7.1.4.4.1.6.1.3]
b. 4 Aug 1864
12
Bertha C Capron
[1.2.1.1.7.1.4.4.1.6.1.4]
b. 16 Mar 1868 [
=>
]
12
William Cargill Capron
[1.2.1.1.7.1.4.4.1.6.1.5]
b. 27 Jul 1869 [
=>
]
11
Ezra Wood Chapin
[1.2.1.1.7.1.4.4.1.6.2]
b. 7 Jun 1836 d. 31 Mar 1909
Ellen Frances Cooper
b. 30 Dec 1835
12
Janet Chapin
[1.2.1.1.7.1.4.4.1.6.2.1]
b. 28 May 1870
11
Edwin Chapin
[1.2.1.1.7.1.4.4.1.6.3]
b. 7 Jun 1836 d. 27 Sep 1836
10
Margaret Ann Chapin
[1.2.1.1.7.1.4.4.1.7]
b. 16 Jun 1808 d. 15 Nov 1897
10
Bezaileel Taft Chapin
[1.2.1.1.7.1.4.4.1.8]
b. 21 Oct 1810 d. 28 May 1855
10
Samuel Judson Chapin
[1.2.1.1.7.1.4.4.1.9]
b. 27 Aug 1812 d. 18 Nov 1908
10
Son Chapin
[1.2.1.1.7.1.4.4.1.10]
b. 15 Oct 1815
10
Gardner Spring Chapin
[1.2.1.1.7.1.4.4.1.11]
b. 2 Oct 1817 d. 4 Aug 1892
10
Josiah Spring Chapin
[1.2.1.1.7.1.4.4.1.12]
b. 24 Aug 1820 d. 26 Dec 1882
8
Lois Taft
[1.2.1.1.7.1.4.5]
b. 28 Apr 1757 d. 10 Feb 1792
Caleb Farnum
b. 9 Nov 1753 d. 3 Jan 1829
9
Royal Farnham
[1.2.1.1.7.1.4.5.1]
b. 28 Nov 1775 d. 3 Sep 1845
+
Betsey Whitney
b. 29 Jul 1779
9
Easman Farnum
[1.2.1.1.7.1.4.5.2]
b. 22 Dec 1777
Rebecca Chamberlain
b. 10 Feb 1778
10
Almira Farnum
[1.2.1.1.7.1.4.5.2.1]
b. 1801 d. 24 Jan 1829
10
George V R Farnham
[1.2.1.1.7.1.4.5.2.2]
b. 12 Sep 1812 d. 3 Jul 1871
Nancy
b. 1815
11
Oscar W Farnham
[1.2.1.1.7.1.4.5.2.2.1]
b. 12 Nov 1835
9
Caleb Farnum
[1.2.1.1.7.1.4.5.3]
b. 15 Jul 1781 d. 16 Jun 1863
Silvania Allen
b. 5 Mar 1782 d. 13 Oct 1846
10
Elizabeth F Farnham
[1.2.1.1.7.1.4.5.3.1]
b. 21 Apr 1805 d. 20 Jul 1827
Mellen Garner Kempton
b. 20 Feb 1805 d. 4 Feb 1893
11
George Mellen Kempton
[1.2.1.1.7.1.4.5.3.1.1]
b. 13 Jun 1827 d. 29 Mar 1911
10
George A Farnham
[1.2.1.1.7.1.4.5.3.2]
b. 27 Jun 1807
+
Angeline Hanks
b. 1808 d. 1 Jan 1877
+
Sarah Taylor
b. Abt 1814
10
Clarissa Taft Farnum
[1.2.1.1.7.1.4.5.3.3]
b. 27 Jun 1807 d. 26 Oct 1839
+
Dugald Cameron Taylor
10
Edward Judson Farnham
[1.2.1.1.7.1.4.5.3.4]
b. 16 Mar 1809 d. 11 Jul 1894
Lucy G Goff
b. Abt 1809 d. 12 Oct 1876
11
Frances Farnham
[1.2.1.1.7.1.4.5.3.4.1]
b. 1830 d. 1857
11
Antoinette Farnham
[1.2.1.1.7.1.4.5.3.4.2]
b. Abt 1833
+
Edwin B Hall
b. Abt 1832
11
Louise Adelaide Farnum
[1.2.1.1.7.1.4.5.3.4.3]
b. Abt 1835
+
Alfred Stewart Brown
b. Abt 1834
11
Sylvania Allen Farnham
[1.2.1.1.7.1.4.5.3.4.4]
b. 1836
11
Fanny Louisa Farnham
[1.2.1.1.7.1.4.5.3.4.5]
b. 1838
+
J Milton Carpenter
b. 1835
11
William Carlton Farnham
[1.2.1.1.7.1.4.5.3.4.6]
b. 1840
10
Caroline Farnum
[1.2.1.1.7.1.4.5.3.5]
b. 13 Aug 1810 d. 26 Aug 1810
10
Carleton Lee Farnham
[1.2.1.1.7.1.4.5.3.6]
b. 13 Jul 1811
Sarah Gaylord
b. Abt 1818 d. 23 Jul 1892
11
Edward G Farnum
[1.2.1.1.7.1.4.5.3.6.1]
b. 27 Jan 1840
11
Charles Caleb Farnum
[1.2.1.1.7.1.4.5.3.6.2]
b. 11 Sep 1841
11
Emily Adelaide Farnum
[1.2.1.1.7.1.4.5.3.6.3]
b. 21 Oct 1843 d. 24 Apr 1883
+
Sanford Jenkins
b. 1839 d. 1873
11
William Haddard Farnum
[1.2.1.1.7.1.4.5.3.6.4]
b. 27 Jan 1845 d. 22 Jan 1850
11
George Eugene Farnum
[1.2.1.1.7.1.4.5.3.6.5]
b. 9 Nov 1845
Mary Alice Richmond
b. 1845
12
Inez G. Farnum
[1.2.1.1.7.1.4.5.3.6.5.1]
b. 28 Dec 1887
12
Gaylord Richard Farnum
[1.2.1.1.7.1.4.5.3.6.5.2]
b. 17 Jan 1891
11
William Stoddard Farnum
[1.2.1.1.7.1.4.5.3.6.6]
b. 27 Jan 1848 d. 22 Jan 1856
11
Clarence Asher Farnum
[1.2.1.1.7.1.4.5.3.6.7]
b. 7 Oct 1850
+
Corinne A Hanks
b. Abt 1852
11
Mary Gaylord Farnum
[1.2.1.1.7.1.4.5.3.6.8]
b. 14 Jan 1854
+
Chauncey B Macken
b. 1854
10
William A Farnham
[1.2.1.1.7.1.4.5.3.7]
b. 13 Mar 1813 d. 28 Feb 1814
10
William A Farnham
[1.2.1.1.7.1.4.5.3.8]
b. 13 Aug 1815 d. 2 Aug 1860
+
Pheobe Adams
b. 1821
10
Dorcas Adelaide Farnum
[1.2.1.1.7.1.4.5.3.9]
b. 9 Jun 1820 d. 13 Aug 1842
10
Mary Frances Farnham
[1.2.1.1.7.1.4.5.3.10]
b. 29 Jul 1823 d. 1 Jan 1847
+
William Stoddard
+
Sally Jones
b. 1783 d. 12 May 1874
9
Clarissa Farnam
[1.2.1.1.7.1.4.5.4]
b. 22 Aug 1784
+
Elihu Morgan
b. 1780
8
Mercy Taft
[1.2.1.1.7.1.4.6]
b. 5 Mar 1758 d. 18 Feb 1843
Otis Russell
b. 9 Dec 1733
9
Meribah Russell
[1.2.1.1.7.1.4.6.1]
b. 1805 d. Aft 1860
8
Israel Taft
[1.2.1.1.7.1.4.7]
b. 1 Mar 1761 d. 24 Apr 1842
Submit Read
b. 21 Jun 1763 d. 17 May 1841
9
Ruth Taft
[1.2.1.1.7.1.4.7.1]
b. 5 Jan 1783
Benjamin Farrow
b. 9 Mar 1782 d. 17 Oct 1861
10
Drucilla Farrow
[1.2.1.1.7.1.4.7.1.1]
b. 10 Apr 1805 d. 7 Nov 1896
10
Theodore Grey Farrow
[1.2.1.1.7.1.4.7.1.2]
b. 25 Feb 1807 d. 23 Jan 1907
10
Submit Farrow
[1.2.1.1.7.1.4.7.1.3]
b. 4 Jan 1809 d. 22 Nov 1882
10
Cecelia Farrow
[1.2.1.1.7.1.4.7.1.4]
b. 26 May 1810 d. 18 Jul 1835
10
Israel Taft Farrow
[1.2.1.1.7.1.4.7.1.5]
b. 25 May 1812 d. 23 Apr 1903
10
Franklin Farrow
[1.2.1.1.7.1.4.7.1.6]
b. 31 Aug 1813 d. 3 Feb 1892
10
Independence Farrow
[1.2.1.1.7.1.4.7.1.7]
b. 4 Jul 1815 d. 7 Sep 1891
10
Constantine Farrow
[1.2.1.1.7.1.4.7.1.8]
b. 11 Mar 1817 d. 28 Feb 1871
10
Lucy Farrow
[1.2.1.1.7.1.4.7.1.9]
b. 13 Oct 1819 d. 12 Jul 1850
10
Benjamin Farrow
[1.2.1.1.7.1.4.7.1.10]
b. 13 Oct 1819 d. 17 Oct 1819
10
Caleb Walter Farrow
[1.2.1.1.7.1.4.7.1.11]
b. 16 Jan 1823 d. 26 Jul 1860
10
Emeline Farrow
[1.2.1.1.7.1.4.7.1.12]
b. 16 Jun 1824 d. 30 Aug 1842
10
Miranda Farrow
[1.2.1.1.7.1.4.7.1.13]
b. 5 Jul 1827 d. 2 Feb 1877
9
Clarisa Taft
[1.2.1.1.7.1.4.7.2]
b. 5 Mar 1786
9
Elzaphan Taft
[1.2.1.1.7.1.4.7.3]
b. 15 Feb 1788 d. 23 Mar 1847
Elisabeth Fowler
b. 1791 d. 30 Sep 1871
10
Gilbert Chase Taft
[1.2.1.1.7.1.4.7.3.1]
b. 22 Nov 1813
10
Emila Angenett Taft
[1.2.1.1.7.1.4.7.3.2]
b. 15 Sep 1815
10
Samuel Read Taft
[1.2.1.1.7.1.4.7.3.3]
b. 6 Aug 1818 d. 30 Aug 1835
10
John E Taft
[1.2.1.1.7.1.4.7.3.4]
b. 25 Feb 1821
10
Cyrus Taft
[1.2.1.1.7.1.4.7.3.5]
b. 27 Nov 1824 d. 6 Feb 1832
10
Lucinda M Taft
[1.2.1.1.7.1.4.7.3.6]
b. 26 Jul 1827
10
Elizabeth G. Taft
[1.2.1.1.7.1.4.7.3.7]
b. 17 May 1833
9
Abigail Taft
[1.2.1.1.7.1.4.7.4]
b. 9 Feb 1790 d. 5 Jun 1791
9
Laurana Taft
[1.2.1.1.7.1.4.7.5]
b. 13 May 1792
Cheany Taft
b. 8 Dec 1787 d. 13 Feb 1840
10
Caleb Walter Taft
[1.2.1.1.7.1.4.7.5.1]
b. 11 Oct 1813 d. 19 Dec 1813
10
Henry Cheney Taft
[1.2.1.1.7.1.4.7.5.2]
b. 20 Apr 1815
9
Lydia Mariah Taft
[1.2.1.1.7.1.4.7.6]
b. 10 Jul 1794
Washington White
b. 17 May 1796
10
Ruth Taft White
[1.2.1.1.7.1.4.7.6.1]
b. 16 Jun 1819
10
Sarah Ann White
[1.2.1.1.7.1.4.7.6.2]
b. 17 Sep 1821
10
Lurana Taft White
[1.2.1.1.7.1.4.7.6.3]
b. 14 Apr 1823
10
Lydia Mariah White
[1.2.1.1.7.1.4.7.6.4]
b. 3 Apr 1825
10
Eunice Fletcher White
[1.2.1.1.7.1.4.7.6.5]
b. 1 Jan 1827
10
Mary Elizabeth White
[1.2.1.1.7.1.4.7.6.6]
b. 15 Sep 1829
10
Margaret B White
[1.2.1.1.7.1.4.7.6.7]
b. 20 Jul 1833
10
Caroline Frances White
[1.2.1.1.7.1.4.7.6.8]
b. 20 Jan 1835
10
Henry Kirk White
[1.2.1.1.7.1.4.7.6.9]
b. 10 May 1837
10
William Edwards White
[1.2.1.1.7.1.4.7.6.10]
b. 8 Mar 1839
10
Lucy B White
[1.2.1.1.7.1.4.7.6.11]
b. 16 Oct 1841
10
Emma Jane White
[1.2.1.1.7.1.4.7.6.12]
b. 18 Feb 1845
9
Cyrus Taft
[1.2.1.1.7.1.4.7.7]
b. 3 Feb 1797
Lucinda Morse
b. 1800 d. 25 Jul 1860
10
Gustavus Elzaphan Taft
[1.2.1.1.7.1.4.7.7.1]
b. 29 Aug 1829 d. 23 Jun 1888
10
Son Taft
[1.2.1.1.7.1.4.7.7.2]
b. 1831
10
Peter Morse Taft
[1.2.1.1.7.1.4.7.7.3]
b. 1833
10
Edmond M Taft
[1.2.1.1.7.1.4.7.7.4]
b. 1834 d. 25 Oct 1858
9
Louis Taft
[1.2.1.1.7.1.4.7.8]
b. 25 Apr 1801
8
Eastman Taft
[1.2.1.1.7.1.4.8]
b. 16 Jun 1763 d. 29 Apr 1829
Chloa Taft
b. 25 Nov 1763 d. 4 May 1783
9
Eastman Taft
[1.2.1.1.7.1.4.8.1]
b. 2 May 1783 d. 8 Aug 1857
Hannah Taft
b. 1 Nov 1763 d. 3 Jul 1832
9
Chloe Taft
[1.2.1.1.7.1.4.8.2]
b. 7 Jul 1785 d. 25 Apr 1826
John Perry Benson
b. 22 Jul 1781 d. 21 Jan 1842
10
Charlotte Taft Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.1]
b. 30 Sep 1807 d. 16 Jul 1878
Moses Dyer
b. 1803 d. Aft 1841
11
Merril B Dyer
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.1.1]
b. 2 Apr 1844 d. 2 Apr 1859
11
George Franklin Dyer
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.1.2]
b. 22 Jan 1846 d. 27 Feb 1917
Ellen Jane Hubbard
b. 1848 d. 1925
12
Merrill Eugene Dyer
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.1.2.1]
b. 18 Dec 1869 d. 1926 [
=>
]
11
Chloe Allice Dyer
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.1.3]
b. 5 May 1848 d. 1932
Sanford Brown
b. 10 Feb 1844 d. 1883
12
Charlotta B Brown
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.1.3.1]
b. 22 Feb 1871
12
Paul Brown
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.1.3.2]
b. 12 Jan 1873 d. 24 Nov 1952 [
=>
]
12
Sanford Brown
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.1.3.3]
b. 17 Mar 1876 d. 5 Sep 1905
12
Elizabeth Brown
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.1.3.4]
b. 25 May 1879
12
Neil Brown
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.1.3.5]
b. 25 Mar 1882 d. 5 Nov 1913
11
Angelne A Dyer
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.1.4]
b. 6 Sep 1852
Orison J Batchelor
b. 11 Jul 1851 d. 10 Jan 1913
12
Chloe Edith Bachelor
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.1.4.1]
b. 11 Sep 1873
12
Nina F Bachelor
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.1.4.2]
b. 30 Nov 1875
12
Maria Frances Bachelor
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.1.4.3]
b. 30 Nov 1875
10
Ezra Taft Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2]
b. 22 Feb 1811 d. 3 Sep 1869
Pamelia Andrus
b. 21 Oct 1809 d. 14 Sep 1877
11
Charles Agustus Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.1]
b. 26 Sep 1832 d. 14 Oct 1833
11
Chloe Jane Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.2]
b. 1835 d. 1835
11
Charles Augustus Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.3]
b. 9 Jul 1837 d. 18 Feb 1873
11
Jonathan Parsons Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.4]
b. Mar 1841 d. Mar 1841
11
Adin Parsons Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.5]
b. Mar 1841 d. Mar 1841
11
Pamelia Emma Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.6]
b. 28 Feb 1842 d. 10 Feb 1892
11
Harvey Andrus Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.7]
b. 26 Sep 1844 d. 26 Sep 1844
11
Isabella Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.8]
b. 9 Mar 1846 d. 10 Feb 1922
11
Charlotte Taft Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.9]
b. 4 Jul 1850 d. 30 Nov 1918
Winfield Scott Norcross
b. 16 Jul 1844 d. 7 Jan 1915
12
Irving Norcross
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.9.1]
b. 1880
12
Winfield Irvin Norcross
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.9.2]
b. 18 Jun 1884
Adeline Brooks Andrus
b. 18 Mar 1813 d. 20 Apr 1898
11
George Taft Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.10]
b. 1 May 1846 d. 16 May 1919
Louisa Alexandrine Ballif
b. 25 Feb 1850 d. 7 Feb 1922
12
Louisa "Lulu" Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.10.1]
b. 28 Mar 1869 d. 15 Jul 1938 [
=>
]
12
Ezra Taft Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.10.2]
b. 6 Aug 1871 d. 28 Aug 1871
12
Elise Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.10.3]
b. 10 Mar 1873 d. 22 Aug 1937 [
=>
]
12
George Taft Benson, Jr
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.10.4]
b. 24 Jun 1875 d. 13 Aug 1934 [
=>
]
12
Serge Ballif Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.10.5]
b. 2 Oct 1877 d. 18 Jan 1959 [
=>
]
12
Adeline Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.10.6]
b. 31 Jul 1879 d. 27 Jan 1960 [
=>
]
12
Florence Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.10.7]
b. 31 Jul 1879 d. 5 Nov 1967 [
=>
]
12
William Kennedy Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.10.8]
b. 9 Feb 1882 d. 28 Feb 1882
12
Frank Taft Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.10.9]
b. 23 Apr 1883 d. 19 Feb 1923 [
=>
]
12
Marie Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.10.10]
b. 19 Jul 1885 d. 6 Mar 1891
12
Carmen Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.10.11]
b. 7 Nov 1887 d. 5 Jul 1974 [
=>
]
12
Jenny Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.10.12]
b. 30 Jun 1890 d. 12 Jul 1970 [
=>
]
12
Kathinka "Kinnie" Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.10.13]
b. 15 Mar 1894 d. 20 May 1960 [
=>
]
11
Florence Adeline Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.11]
b. 17 Sep 1851 d. 25 Dec 1852
11
Nellie Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.12]
b. 30 Nov 1851 d. 24 Jan 1885
11
Frank Andrus Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.13]
b. 16 Oct 1853 d. 5 May 1937
Amanda Charlotta Eliason
b. 4 Jun 1861 d. 12 Mar 1922
12
Eva A Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.13.1]
b. 6 Jul 1882 d. 10 Aug 1946
12
Blanche Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.13.2]
b. 7 May 1888 d. 12 Sep 1979
12
Edna Mae Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.13.3]
b. 19 Oct 1890 d. 19 Mar 1976
12
Frank Andrus Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.13.4]
b. 30 Apr 1895 d. 18 Dec 1968
12
Eleanora Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.13.5]
b. 30 Nov 1896 d. 2 Oct 1992
12
Karl Eliason Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.13.6]
b. 21 Apr 1899 d. 21 Oct 1980
12
Adeline Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.13.7]
b. 14 Mar 1904 d. 5 May 1904
12
George Taft Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.13.8]
b. 17 Aug 1905 d. 18 Feb 1942
11
Samuel Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.14]
b. 1853
Eliza Ann Perry
b. 30 Mar 1828 d. 30 Apr 1913
11
Alice Eliza Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.15]
b. 11 Aug 1848 d. 3 Jun 1923
11
John Perry Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.16]
b. 24 Sep 1849 d. 4 Jan 1921
11
Malina Adelaide Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.17]
b. 21 Sep 1851 d. 31 Jul 1918
11
Orrin William Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.18]
b. 4 Oct 1853 d. 17 May 1917
11
Carrie Stella Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.19]
b. 22 May 1860 d. 15 Mar 1928
11
Abbie Della Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.20]
b. 16 Oct 1862 d. 22 Oct 1925
11
Grace Ann Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.21]
b. 31 Jan 1867 d. 15 Dec 1924
Elizabeth Gollaher
b. 30 Dec 1831 d. 4 May 1904
11
Fredrick Gollaher Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.22]
b. 17 Jan 1855 d. 6 Jan 1915
11
Brigham Young Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.23]
b. 17 Dec 1858 d. 11 Jul 1938
11
Luella Gollaher Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.24]
b. 12 Nov 1860 d. 22 Jul 1881
11
William C Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.25]
b. 11 Nov 1862 d. Sep 1937
11
Hyrum Smith Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.26]
b. 3 May 1864 d. 4 May 1935
11
Edith Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.27]
b. 22 Apr 1867 d. 11 Feb 1925
11
Lizzie Gollaher Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.28]
b. 9 Jul 1869 d. 30 Jul 1946
Olive Mary Knight
b. 24 Jan 1830 d. 27 Mar 1905
11
Louisa Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.29]
b. 29 Jun 1852 d. 29 Nov 1878
11
Heber Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.30]
b. Abt 1860 d. Bef 1868
11
Moroni Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.31]
b. 5 Nov 1861 d. 8 Jan 1934
11
Lorenzo Taft Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.32]
b. 3 Aug 1863 d. 6 Nov 1950
11
Joseph Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.33]
b. 13 Jul 1865 d. 5 Jun 1941
11
Ida May Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.34]
b. 16 Apr 1867 d. 30 Jun 1929
11
Don Carlos Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.35]
b. 29 Sep 1869 d. 19 Jan 1935
Mary Marie Larsen
b. 19 Dec 1843 d. 21 Feb 1926
11
Walter Taft Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.36]
b. 17 Jun 1867 d. 6 Jun 1957
11
Henry Taft Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.2.37]
b. 19 Mar 1869 d. 24 Feb 1947
+
Desdemona Wadsworth Fullmer
b. 6 Oct 1809 d. 9 Feb 1886
+
Lucinda Burton
b. 22 Oct 1825 d. 1 Oct 1863
10
George Taft Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.3]
b. Abt 1813
Prudence Maria Gifford
b. Abt 1815
11
Walter Everet Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.3.1]
b. 13 Sep 1857 d. 29 Apr 1907
Laura Frances Caldwell
b. 1862
12
Laura Livice Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.3.1.1]
b. 9 Oct 1883 d. 14 Feb 1911 [
=>
]
12
George T Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.3.1.2]
b. Feb 1885
10
Hannah Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.4]
b. 18 Sep 1816
Henry Dodge
b. 15 Dec 1812 d. 22 Jun 1883
11
John M Dodge
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.4.1]
b. 1838 d. 14 Feb 1898
11
Abbie R Dodge
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.4.2]
b. 1850 d. 27 Sep 1916
John Averell
b. 1846 d. 19 Aug 1895
12
Elizabeth Alice Averell
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.4.2.1]
b. 13 Apr 1884 d. 4 Feb 1901
+
William Cotter Ball
b. 1865
10
Abbie Ann Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.5]
b. Abt 1809 d. 21 Sep 1883
Calvin Rawson
b. 13 May 1797 d. 21 Jan 1868
11
Son Rawson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.5.1]
b. Abt 1828 d. Abt 1838
10
John M Benson
[1.2.1.1.7.1.4.8.2.6]
b. 1819 d. 12 Aug 1829
9
Ezra Taft
[1.2.1.1.7.1.4.8.3]
b. 6 Mar 1793 d. 19 Feb 1808
7
Hannah Taft
[1.2.1.1.7.1.5]
b. 16 Nov 1726 d. 15 Mar 1802
Elijah Clarke Benjamin
b. 8 Jun 1725 d. 1768
8
Elias Benjamin
[1.2.1.1.7.1.5.1]
b. 4 May 1750 d. 8 Apr 1823
Rhoda Paddock
b. 9 Sep 1785 d. 5 Jun 1858
9
Deborah Benjamin
[1.2.1.1.7.1.5.1.1]
b. 25 Apr 1803 d. 6 Dec 1871
9
Ezra H. Benjamin
[1.2.1.1.7.1.5.1.2]
b. 21 May 1804 d. 20 Jul 1876
9
Edmund Benjamin
[1.2.1.1.7.1.5.1.3]
b. 28 Jan 1806 d. 25 Nov 1887
9
Robert L Benjamin
[1.2.1.1.7.1.5.1.4]
b. 14 Jun 1808 d. 20 Jul 1892
9
Hannah Almedia Benjamin
[1.2.1.1.7.1.5.1.5]
b. 29 Sep 1810 d. Abt 1870
9
John Mills Benjamin
[1.2.1.1.7.1.5.1.6]
b. 5 Jun 1813 d. 1849
9
Isaac Paddock Benjamin
[1.2.1.1.7.1.5.1.7]
b. 21 Jul 1815 d. 5 Apr 1892
9
Mary E Benjamin
[1.2.1.1.7.1.5.1.8]
b. 1 Sep 1817 d. 3 Dec 1819
9
William F Benjamin
[1.2.1.1.7.1.5.1.9]
b. 18 Apr 1820 d. 10 Aug 1869
9
David E Benjamin
[1.2.1.1.7.1.5.1.10]
b. 1 May 1822 d. 25 Aug 1890
9
Mary Elizabeth Benjamin
[1.2.1.1.7.1.5.1.11]
b. 24 Jun 1824 d. 2 Oct 1894
9
Sidney S Benjamin
[1.2.1.1.7.1.5.1.12]
b. 19 Jul 1826 d. 7 May 1862
9
Jane Ann Benjamin
[1.2.1.1.7.1.5.1.13]
b. 7 Dec 1829 d. 29 Mar 1915
8
Chester Benjamin
[1.2.1.1.7.1.5.2]
b. 9 Feb 1751 d. 1830
8
William Benjamin
[1.2.1.1.7.1.5.3]
b. 6 Mar 1753
8
Captain Elijah Taft Benjamin
[1.2.1.1.7.1.5.4]
b. 27 Dec 1755 d. 17 Jun 1819
Elizabeth Paddock
b. 1 Nov 1762 d. 26 Apr 1822
9
Elias Paddock Benjamin
[1.2.1.1.7.1.5.4.1]
b. 6 May 1783 d. 27 Nov 1866
9
David Benjamin
[1.2.1.1.7.1.5.4.2]
b. 18 May 1785 d. 18 Feb 1825
9
Elijah E Benjamin
[1.2.1.1.7.1.5.4.3]
b. 26 Oct 1788 d. 19 May 1880
9
Charles Benjamin
[1.2.1.1.7.1.5.4.4]
b. 7 Oct 1789 d. 10 Feb 1874
9
Daughter Benjamin
[1.2.1.1.7.1.5.4.5]
b. 1791
9
Frederick B Benjamin
[1.2.1.1.7.1.5.4.6]
b. 1794 d. 1868
9
Aaron Benjamin
[1.2.1.1.7.1.5.4.7]
b. 1801 d. 4 Feb 1883
9
Loretta Benjamin
[1.2.1.1.7.1.5.4.8]
b. 5 Feb 1804 d. 8 Feb 1886
8
Cyrus Benjamin
[1.2.1.1.7.1.5.5]
b. 7 Jul 1762 d. 19 Jul 1817
Rhoda Maria Dibble
b. 7 Oct 1771 d. 8 Dec 1817
9
Mary Crosby Benjamin
[1.2.1.1.7.1.5.5.1]
b. 11 Oct 1790
9
Hannah Benjamin
[1.2.1.1.7.1.5.5.2]
b. 2 Jan 1792 d. 1 Jan 1794
9
David C Benjamin
[1.2.1.1.7.1.5.5.3]
b. 7 Nov 1793
9
Anna Benjamin
[1.2.1.1.7.1.5.5.4]
b. 22 Jan 1796 d. 9 Oct 1817
9
Annis Benjamin
[1.2.1.1.7.1.5.5.5]
b. 10 Feb 1798 d. 16 Jun 1869
9
Peter Benjamin
[1.2.1.1.7.1.5.5.6]
b. 14 Feb 1800 d. 2 Sep 1839
9
Cyrus Benjamin
[1.2.1.1.7.1.5.5.7]
b. 11 Jul 1801
9
Nathaniel Benjamin
[1.2.1.1.7.1.5.5.8]
b. 23 Jun 1803
9
Charles J Benjamin
[1.2.1.1.7.1.5.5.9]
b. 17 Feb 1805 d. 1877
9
Elijah Benjamin
[1.2.1.1.7.1.5.5.10]
b. 28 May 1807
9
Eliza "Wealthy" Benjamin
[1.2.1.1.7.1.5.5.11]
b. 28 May 1807 d. 28 Jan 1862
9
Joel Samuel Benjamin
[1.2.1.1.7.1.5.5.12]
b. 17 Apr 1809 d. 4 Feb 1882
9
Catherine E Benjamin
[1.2.1.1.7.1.5.5.13]
b. 18 Jan 1814
9
Cyrus S Benjamin
[1.2.1.1.7.1.5.5.14]
b. 13 Jun 1816
9
Daniel W Benjamin
[1.2.1.1.7.1.5.5.15]
b. 13 Jun 1816 d. 2 Jun 1892
8
Hannah Benjamin
[1.2.1.1.7.1.5.6]
b. 7 Jul 1762 d. 13 May 1840
8
Mary Benjamin
[1.2.1.1.7.1.5.7]
b. 7 Jul 1768 d. 5 Feb 1849
8
Darius Benjamin
[1.2.1.1.7.1.5.8]
b. 17 Jan 1758 d. 12 Feb 1850
7
Elisha Taft
[1.2.1.1.7.1.6]
b. 3 May 1728 d. 3 Mar 1791
Experience Taft
b. 7 Apr 1733 d. 15 Mar 1817
8
Hannah Taft
[1.2.1.1.7.1.6.1]
b. 16 Mar 1758
8
Elisha Taft
[1.2.1.1.7.1.6.2]
b. 4 Mar 1761 d. 16 Jan 1820
Mary Sadler
b. 15 Aug 1768 d. 1800
9
Hiram Taft
[1.2.1.1.7.1.6.2.1]
b. 2 Apr 1789 d. 15 Nov 1794
9
Elisha Taft
[1.2.1.1.7.1.6.2.2]
b. 23 Jul 1791 d. 26 Feb 1858
9
Ormon Taft
[1.2.1.1.7.1.6.2.3]
b. 11 Nov 1793 d. 23 Jan 1794
9
Mary Taft
[1.2.1.1.7.1.6.2.4]
b. 23 May 1795 d. 23 Feb 1875
8
Sarah Taft
[1.2.1.1.7.1.6.3]
b. 21 Mar 1763 d. 11 Oct 1835
Ezra Wood, Jr
b. 12 Mar 1759 d. 10 May 1837
9
Ezra Wood
[1.2.1.1.7.1.6.3.1]
b. 25 Oct 1781
9
Experience Wood
[1.2.1.1.7.1.6.3.2]
b. 16 Mar 1783 d. 14 Oct 1818
9
Sarah Wood
[1.2.1.1.7.1.6.3.3]
b. 7 Aug 1784
9
Elisha Wood
[1.2.1.1.7.1.6.3.4]
b. 24 Apr 1786 d. 19 Oct 1797
9
Jonathan Wood
[1.2.1.1.7.1.6.3.5]
b. 8 Oct 1787 d. 26 Feb 1846
9
Anna Wood
[1.2.1.1.7.1.6.3.6]
b. 31 Aug 1789 d. 20 Mar 1832
9
Chapin Wood
[1.2.1.1.7.1.6.3.7]
b. 2 Apr 1792
9
Lucy Wood
[1.2.1.1.7.1.6.3.8]
b. 11 Nov 1794 d. 10 Dec 1826
9
Silva Wood
[1.2.1.1.7.1.6.3.9]
b. 29 Apr 1796
9
Silva Wood
[1.2.1.1.7.1.6.3.10]
b. 29 Apr 1796
9
Phila Wood
[1.2.1.1.7.1.6.3.11]
b. 5 Jul 1798
9
Elisha Wood
[1.2.1.1.7.1.6.3.12]
b. 7 Nov 1800
9
Simeon Wood
[1.2.1.1.7.1.6.3.13]
b. 5 Jan 1805
8
Israel Taft
[1.2.1.1.7.1.6.4]
b. 12 Feb 1766
8
Joseph Taft
[1.2.1.1.7.1.6.5]
b. 15 Sep 1768 d. Aft 29 Sep 1815
Sarah Farrar
b. 14 Sep 1764 d. 5 Aug 1810
9
Experience
[1.2.1.1.7.1.6.5.1]
b. 5 Feb 1792
9
Amiel F Taft
[1.2.1.1.7.1.6.5.2]
b. 1 Oct 1794 d. 29 Nov 1869
9
Roxalana Taft
[1.2.1.1.7.1.6.5.3]
b. 22 Jan 1798
9
Sofrona Taft
[1.2.1.1.7.1.6.5.4]
b. 17 Jun 1800
9
Esquire Taft
[1.2.1.1.7.1.6.5.5]
b. 28 Apr 1803 d. 11 Mar 1865
9
Deborah R Taft
[1.2.1.1.7.1.6.5.6]
b. 6 Jan 1806
+
Marcy Stockwell
b. Abt 1794
7
Mercy Taft
[1.2.1.1.7.1.7]
b. 7 Apr 1733 d. 27 Mar 1801
Benjamin Green
b. 11 Aug 1734 d. 16 Aug 1797
8
Benjamin Green
[1.2.1.1.7.1.7.1]
b. 6 Jan 1754
8
Israel Green
[1.2.1.1.7.1.7.2]
b. 22 Jun 1755
8
Margery Green
[1.2.1.1.7.1.7.3]
b. 1 Feb 1758 d. 22 Sep 1838
Josiah Taft
b. 28 Oct 1752 d. 8 Jan 1846
9
Josiah Taft
[1.2.1.1.7.1.7.3.1]
b. 10 Apr 1778 d. 30 Dec 1790
9
Lydia Taft
[1.2.1.1.7.1.7.3.2]
b. 13 Feb 1780
9
Israel Taft
[1.2.1.1.7.1.7.3.3]
b. 30 Jul 1782 d. 10 Apr 1840
Ann Taft
b. 23 Aug 1791 d. 17 Dec 1821
10
Julia Ann Taft
[1.2.1.1.7.1.7.3.3.1]
b. 15 Apr 1810
10
Marcy Taft
[1.2.1.1.7.1.7.3.3.2]
b. 2 Jun 1812
+
Freeland Stockwell
b. 19 Mar 1808 d. 17 Jun 1887
9
Benjamin Taft
[1.2.1.1.7.1.7.3.4]
b. 3 Aug 1784 d. 13 May 1863
9
Mercy Taft
[1.2.1.1.7.1.7.3.5]
b. 1786 d. 12 Jun 1803
9
Polly Taft
[1.2.1.1.7.1.7.3.6]
b. 23 Sep 1790
9
Andre Taft
[1.2.1.1.7.1.7.3.7]
b. 25 Jun 1792 d. 26 Jun 1850
Sarah Williams Baker
b. 8 Feb 1796
10
Margary Ann Taft
[1.2.1.1.7.1.7.3.7.1]
b. 4 May 1818 d. 4 Nov 1904
Charles W Hartwell
b. 1816 d. Bef 1904
11
Margery Hartwell
[1.2.1.1.7.1.7.3.7.1.1]
b. 30 Oct 1849
10
Caroline Taft
[1.2.1.1.7.1.7.3.7.2]
b. 21 Aug 1821 d. 7 Nov 1907
John Flint Smith
b. 7 Nov 1815
11
Mary Flint Smith
[1.2.1.1.7.1.7.3.7.2.1]
b. 31 Mar 1850 d. 21 Aug 1852
11
Effie Caroline Smith
[1.2.1.1.7.1.7.3.7.2.2]
b. 28 Nov 1857 d. Aft 1902
9
Judson Taft
[1.2.1.1.7.1.7.3.8]
b. 14 Feb 1793 d. 26 Jan 1891
9
Eunice Taft
[1.2.1.1.7.1.7.3.9]
b. 14 Mar 1795
9
Harry Taft
[1.2.1.1.7.1.7.3.10]
b. 5 Mar 1797
9
Guilford Hodges Taft
[1.2.1.1.7.1.7.3.11]
b. 1 Jan 1799 d. 22 Nov 1816
8
Marcy Green
[1.2.1.1.7.1.7.4]
b. 1 Jan 1760 d. 8 Jun 1815
Cummings Taft
b. 27 Aug 1770 d. 22 Jun 1841
9
Ezra Taft
[1.2.1.1.7.1.7.4.1]
b. 13 May 1797 d. 16 Nov 1878
Mercy G White
b. 1796 d. 14 Mar 1822
10
Austin Taft
[1.2.1.1.7.1.7.4.1.1]
b. 1 Mar 1822 d. 4 Sep 1844
Susanna Keith
b. 3 Jan 1801
10
Laura Ann M Taft
[1.2.1.1.7.1.7.4.1.2]
b. 26 Jun 1824 d. 26 May 1855
Oliver Taft
b. 6 Nov 1771 d. 20 Feb 1853
11
Laura Ann Maria Taft
[1.2.1.1.7.1.7.4.1.2.1]
b. 7 Jul 1844
11
Son Taft
[1.2.1.1.7.1.7.4.1.2.2]
b. 7 Jul 1844 d. 21 Jul 1844
11
Joseph K Taft
[1.2.1.1.7.1.7.4.1.2.3]
b. 25 Sep 1846 d. Jul 1868
11
Chloe Jane Taft
[1.2.1.1.7.1.7.4.1.2.4]
b. 25 Nov 1849
10
Lucinda M Taft
[1.2.1.1.7.1.7.4.1.3]
b. 15 Mar 1826 d. 5 Mar 1906
Charles White
b. 1825 d. 25 Mar 1899
11
Alice Maria White
[1.2.1.1.7.1.7.4.1.3.1]
b. 7 May 1865 d. 10 Dec 1892
Everett Burnside Sherman
b. 16 Jun 1862 d. 1935
12
Lillian Maria Sherman
[1.2.1.1.7.1.7.4.1.3.1.1]
b. 12 Jan 1887
12
Waldo Leonard Sherman
[1.2.1.1.7.1.7.4.1.3.1.2]
b. 16 Jan 1889 d. 1956
12
Evelyn L Sherman
[1.2.1.1.7.1.7.4.1.3.1.3]
b. 22 Jun 1891
11
Walter Arnold White
[1.2.1.1.7.1.7.4.1.3.2]
b. 9 May 1869
Ada Mabel Esten
b. 2 Dec 1869
12
Vinton Esten White
[1.2.1.1.7.1.7.4.1.3.2.1]
b. 26 Jun 1899 d. 11 Mar 2002
12
Alton F White
[1.2.1.1.7.1.7.4.1.3.2.2]
b. 1901
12
Allin Taft White
[1.2.1.1.7.1.7.4.1.3.2.3]
b. 11 Apr 1901
10
Artemas K Taft
[1.2.1.1.7.1.7.4.1.4]
b. 24 May 1828 d. 27 Dec 1878
Jane
b. 1827
11
Olive A Taft
[1.2.1.1.7.1.7.4.1.4.1]
b. Abt 1850
11
Albert Eugene Taft
[1.2.1.1.7.1.7.4.1.4.2]
b. 13 Aug 1852
11
Susan Ellen Taft
[1.2.1.1.7.1.7.4.1.4.3]
b. Abt 1859
Smith Henry Thayer
b. 24 Aug 1848
12
Howard A Thayer
[1.2.1.1.7.1.7.4.1.4.3.1]
b. 8 Sep 1891
11
John Taft
[1.2.1.1.7.1.7.4.1.4.4]
b. 3 Jun 1864
11
Jane Taft
[1.2.1.1.7.1.7.4.1.4.5]
b. 3 Jun 1864
10
Uranah Taft
[1.2.1.1.7.1.7.4.1.5]
b. 25 Jan 1831
10
Daines C Taft
[1.2.1.1.7.1.7.4.1.6]
b. 1835
Olive Cleveland Smith
b. 16 Oct 1828 d. 15 Mar 1910
11
George Edward Taft
[1.2.1.1.7.1.7.4.1.6.1]
b. 7 Feb 1860 d. 10 Oct 1860
11
Celinda Grace Taft
[1.2.1.1.7.1.7.4.1.6.2]
b. 19 Aug 1861
11
Albert Smith Taft
[1.2.1.1.7.1.7.4.1.6.3]
b. 7 Feb 1867
10
Susan A Taft
[1.2.1.1.7.1.7.4.1.7]
b. 1838
10
Hannah Jane Taft
[1.2.1.1.7.1.7.4.1.8]
b. 17 Nov 1839 d. 7 Jan 1848
9
Benjamin Taft
[1.2.1.1.7.1.7.4.2]
b. 10 Aug 1798 d. 29 May 1799
9
Benjamin Taft
[1.2.1.1.7.1.7.4.3]
b. 6 May 1800 d. 17 Oct 1828
Martha Bethsheba White
b. 1803
10
Benjamin Lorin Taft
[1.2.1.1.7.1.7.4.3.1]
b. 25 Jun 1823
+
Paulina Wheelock
b. 27 Oct 1827
10
Russell White Taft
[1.2.1.1.7.1.7.4.3.2]
b. 23 Jan 1826 d. 4 Dec 1868
9
Hannah G Taft
[1.2.1.1.7.1.7.4.4]
b. 18 May 1802 d. 8 Jan 1843
Newell Taft
b. 28 Jul 1804 d. 4 Nov 1873
10
Albert Taft
[1.2.1.1.7.1.7.4.4.1]
b. 28 Aug 1823 d. Aft 1874
Sally L Bartlett
b. 14 Oct 1827 d. 1 Sep 1874
11
Charles B Taft
[1.2.1.1.7.1.7.4.4.1.1]
b. Feb 1854 d. 23 Sep 1854
11
Hannah L Taft
[1.2.1.1.7.1.7.4.4.1.2]
b. 5 Feb 1856
10
Marcy Taft
[1.2.1.1.7.1.7.4.4.2]
b. Mar 1829 d. 12 Apr 1830
10
Charles M Taft
[1.2.1.1.7.1.7.4.4.3]
b. Jan 1843 d. 7 Dec 1843
8
Hannah Green
[1.2.1.1.7.1.7.5]
b. 2 Apr 1763
8
Rachel Green
[1.2.1.1.7.1.7.6]
b. 27 Aug 1765
8
Samuel Green
[1.2.1.1.7.1.7.7]
b. 14 Mar 1767
7
Stephen Taft
[1.2.1.1.7.1.8]
b. 21 Aug 1734 d. 3 Feb 1803
Anna Taft
b. 14 Apr 1748 d. 3 Apr 1830
8
Lydia Taft
[1.2.1.1.7.1.8.1]
b. 13 Oct 1766 d. 13 Jan 1847
8
Hazeltine Taft
[1.2.1.1.7.1.8.2]
b. 6 Jan 1769 d. 18 Jul 1856
8
Gravenor Taft
[1.2.1.1.7.1.8.3]
b. 1773 d. 1838
8
Marcy Taft
[1.2.1.1.7.1.8.4]
b. 5 Sep 1775
8
Ephraim Taft
[1.2.1.1.7.1.8.5]
b. 18 Aug 1780
Elisabeth Taft
b. 8 Nov 1784
9
Mary Ann Taft
[1.2.1.1.7.1.8.5.1]
b. 22 May 1805
9
Ephriam Taft
[1.2.1.1.7.1.8.5.2]
b. 8 Feb 1807
8
Lovice Taft
[1.2.1.1.7.1.8.6]
b. 1 Jul 1783
8
Anna Taft
[1.2.1.1.7.1.8.7]
b. 29 Nov 1784
8
Stephen Taft
[1.2.1.1.7.1.8.8]
b. 12 Dec 1787
8
Adolphas Taft
[1.2.1.1.7.1.8.9]
b. 2 Oct 1791
7
Samuel Taft
[1.2.1.1.7.1.9]
b. 23 Sep 1735 d. 2 Aug 1816
Mary Murdock
b. 3 Jan 1742 d. 26 Mar 1785
8
Frederick Taft
[1.2.1.1.7.1.9.1]
b. 19 Jun 1759 d. 10 Feb 1846
Abigail Wood
b. 29 Aug 1761 d. 2 Jun 1851
9
Samuel Taft
[1.2.1.1.7.1.9.1.1]
b. 12 Dec 1782 d. 8 Feb 1842
9
Murdock Taft
[1.2.1.1.7.1.9.1.2]
b. 8 Dec 1784 d. 6 Aug 1820
9
Calista Taft
[1.2.1.1.7.1.9.1.3]
b. 31 Jan 1787 d. 11 Dec 1864
9
Clarinda Taft
[1.2.1.1.7.1.9.1.4]
b. 28 Feb 1789 d. 11 Apr 1877
Cabel Mowry
b. Abt 1783 d. 16 May 1845
10
Emily M Mowry
[1.2.1.1.7.1.9.1.4.1]
b. 13 Oct 1814 d. 25 May 1880
William Collins Boyden
b. 8 May 1811
11
Mary Amanda Boyden
[1.2.1.1.7.1.9.1.4.1.1]
b. 16 Aug 1834
Amos Boyden
b. 4 Aug 1827
12
Henry Pierce Boyden
[1.2.1.1.7.1.9.1.4.1.1.1]
b. 18 Sep 1862
12
Samuel Mowry Boyden
[1.2.1.1.7.1.9.1.4.1.1.2]
b. 8 Dec 1869
12
Son Boyden
[1.2.1.1.7.1.9.1.4.1.1.3]
b. 1 Jul 1871
12
Josiah S Boyden
[1.2.1.1.7.1.9.1.4.1.1.4]
b. 1875 d. 24 Mar 1875
11
William Collins Boyden
[1.2.1.1.7.1.9.1.4.1.2]
b. 3 Apr 1836 d. 20 Mar 1882
11
Sanford H Boyden
[1.2.1.1.7.1.9.1.4.1.3]
b. 20 Dec 1838 d. 18 Sep 1869
11
Decatur M Boyden
[1.2.1.1.7.1.9.1.4.1.4]
b. 21 Aug 1840 d. Abt 1951
Frances L Poland
b. 1845 d. Bef 1955
12
Edith Louise Boyden
[1.2.1.1.7.1.9.1.4.1.4.1]
b. 2 Aug 1863 d. Bef 1979
12
Osborn Decatur Boyden
[1.2.1.1.7.1.9.1.4.1.4.2]
b. 15 Jul 1866
12
Grace Lemond Boyden
[1.2.1.1.7.1.9.1.4.1.4.3]
b. 10 Sep 1872
11
Emily Frances Boyden
[1.2.1.1.7.1.9.1.4.1.5]
b. 19 Jan 1845 d. 17 Sep 1846
11
Emily Ann Boyden
[1.2.1.1.7.1.9.1.4.1.6]
b. 10 Jan 1848 d. Abt 1958
11
Reuben M Boyden
[1.2.1.1.7.1.9.1.4.1.7]
b. 19 Dec 1853 d. 5 Sep 1887
11
Amey Boyden
[1.2.1.1.7.1.9.1.4.1.8]
b. 23 May 1856 d. 30 Sep 1915
10
Decatur Mowrey
[1.2.1.1.7.1.9.1.4.2]
b. 30 Sep 1816 d. 31 Jul 1856
10
Bainbridge Mowry
[1.2.1.1.7.1.9.1.4.3]
b. 23 Jul 1818 d. 1893
10
Albert Mowry
[1.2.1.1.7.1.9.1.4.4]
b. 20 Apr 1822 d. 30 Mar 1900
10
Reuben Ransom Mowrey
[1.2.1.1.7.1.9.1.4.5]
b. 5 Apr 1826
10
Anna Ransom Mowry
[1.2.1.1.7.1.9.1.4.6]
b. 13 Sep 1827 d. 15 Jan 1903
10
Wesley Mowry
[1.2.1.1.7.1.9.1.4.7]
b. 26 May 1830 d. 11 Aug 1833
9
Frederic A Taft
[1.2.1.1.7.1.9.1.5]
b. 7 Apr 1790 d. 18 Sep 1837
9
Nabby Taft
[1.2.1.1.7.1.9.1.6]
b. 7 Jun 1793 d. 19 Jul 1880
9
Harriet Taft
[1.2.1.1.7.1.9.1.7]
b. 25 Jul 1795 d. 3 Sep 1852
9
Parla Parilla Taft
[1.2.1.1.7.1.9.1.8]
b. 5 Mar 1798 d. 26 Sep 1852
9
Ezra Wood Taft
[1.2.1.1.7.1.9.1.9]
b. 26 Aug 1800 d. 8 Feb 1885
9
Mary Ann Taft
[1.2.1.1.7.1.9.1.10]
b. 11 Sep 1803 d. 7 Sep 1850
9
Margaret Taft
[1.2.1.1.7.1.9.1.11]
b. 31 May 1806 d. 23 Jan 1891
8
Sibbel Taft
[1.2.1.1.7.1.9.2]
b. 19 Aug 1760 d. 28 Sep 1761
8
Lyman Taft
[1.2.1.1.7.1.9.3]
b. 14 Mar 1762 d. 24 Jul 1833
8
Mercy Taft
[1.2.1.1.7.1.9.4]
b. 23 Apr 1765 d. 25 Apr 1768
8
Willard Taft
[1.2.1.1.7.1.9.5]
b. 30 Oct 1766 d. 14 Sep 1845
8
Parley Taft
[1.2.1.1.7.1.9.6]
b. 20 Jan 1768 d. 13 Apr 1768
8
Merret Taft
[1.2.1.1.7.1.9.7]
b. 26 Jan 1769
8
Otis Taft
[1.2.1.1.7.1.9.8]
b. 29 Oct 1771
8
Farla Taft
[1.2.1.1.7.1.9.9]
b. 24 Mar 1774 d. 6 Apr 1864
8
Washington Taft
[1.2.1.1.7.1.9.10]
b. 16 Sep 1775
8
Philena Taft
[1.2.1.1.7.1.9.11]
b. 11 Mar 1781 d. 1814
8
George Washington Taft
[1.2.1.1.7.1.9.12]
b. 1 May 1783 d. 30 Nov 1824
Experiance Humes
b. 27 May 1750 d. 15 Jan 1837
8
Dandridge Taft
[1.2.1.1.7.1.9.13]
b. 1 Aug 1787 d. 10 Aug 1832
8
Warner Taft
[1.2.1.1.7.1.9.14]
b. 15 Sep 1789 d. 3 Aug 1837
8
Experiance Taft
[1.2.1.1.7.1.9.15]
b. 10 Jun 1791 d. 30 Nov 1863
8
Polley Taft
[1.2.1.1.7.1.9.16]
b. 18 Mar 1794
7
Margery Taft
[1.2.1.1.7.1.10]
b. 14 May 1738 d. 20 Jan 1813
Simeon Wood
b. 7 Jan 1732 d. 11 May 1802
8
Stephen Wood
[1.2.1.1.7.1.10.1]
b. 14 Oct 1761 d. Abt 1820
8
Simeon Wood, Jr
[1.2.1.1.7.1.10.2]
b. 14 Oct 1761 d. 1819
8
Rhoda Wood
[1.2.1.1.7.1.10.3]
b. 25 May 1763 d. 8 Apr 1832
8
Jerusha Wood
[1.2.1.1.7.1.10.4]
b. 28 Jun 1765 d. 8 Apr 1832
Asa Newell
b. 27 Nov 1761 d. 4 Aug 1808
9
Caleb Newell
[1.2.1.1.7.1.10.4.1]
b. Abt 1786
9
Eabon Carter Newell
[1.2.1.1.7.1.10.4.2]
b. 17 Nov 1788 d. 3 Mar 1831
9
Matilda Newell
[1.2.1.1.7.1.10.4.3]
b. 1793 d. 28 Aug 1830
9
Lucretia Newell
[1.2.1.1.7.1.10.4.4]
b. 24 Sep 1795 d. 29 Dec 1863
John Taft
b. 3 Dec 1792 d. 29 May 1826
10
Robert Taft
[1.2.1.1.7.1.10.4.4.1]
b. 27 May 1819
10
Jacob Taft
[1.2.1.1.7.1.10.4.4.2]
b. 19 May 1823
9
Jerusha Newell
[1.2.1.1.7.1.10.4.5]
b. 7 Nov 1799 d. 31 Oct 1879
9
Asa Newell
[1.2.1.1.7.1.10.4.6]
b. 31 Aug 1803 d. Apr 1865
8
Caleb Wood
[1.2.1.1.7.1.10.5]
b. 2 Jun 1767 d. 24 Jun 1769
8
Willis Wood
[1.2.1.1.7.1.10.6]
b. 14 Jul 1769 d. 5 Oct 1779
8
Nathaniel G Wood
[1.2.1.1.7.1.10.7]
b. 24 Jul 1771 d. 4 Sep 1847
8
Lois Wood
[1.2.1.1.7.1.10.8]
b. 8 Nov 1772 d. 20 Apr 1773
8
Eunice Wood
[1.2.1.1.7.1.10.9]
b. 11 Apr 1773 d. 28 Jun 1791
8
Jesse Wood
[1.2.1.1.7.1.10.10]
b. 29 Aug 1775 d. Bef 1884
8
Mary Wood
[1.2.1.1.7.1.10.11]
b. 3 Jan 1778 d. 3 Jan 1868
8
Sibel Wood
[1.2.1.1.7.1.10.12]
b. 12 Jan 1781 d. Feb 1831
7
Silas Taft
[1.2.1.1.7.1.11]
b. 17 Dec 1739 d. 10 May 1741
7
Rachel Taft
[1.2.1.1.7.1.12]
b. 18 Jul 1742 d. 30 Dec 1747
7
Silas Taft
[1.2.1.1.7.1.13]
b. 5 Nov 1744
Elizabeth Sadler
b. 13 Sep 1754
8
Stephen Taft
[1.2.1.1.7.1.13.1]
b. 22 Feb 1773 d. 26 Oct 1846
8
Silas Taft
[1.2.1.1.7.1.13.2]
b. 2 Jun 1775
8
Israel Taft
[1.2.1.1.7.1.13.3]
b. 22 Sep 1777 d. 19 May 1842
8
Joel Taft
[1.2.1.1.7.1.13.4]
b. 28 Apr 1780
8
Belzaleel Taft
[1.2.1.1.7.1.13.5]
b. 28 Jan 1783 d. 15 Apr 1831
8
Otis Taft
[1.2.1.1.7.1.13.6]
b. 17 Sep 1786 d. 19 Nov 1827
Thankful Benson
b. 29 Aug 1783 d. 11 Apr 1808
9
Tilus Vespasian Taft
[1.2.1.1.7.1.13.6.1]
b. 4 Jun 1806 d. 22 Feb 1889
Sarah Jane Hagar
b. 16 Dec 1810 d. 25 Sep 1852
10
Louis V Taft
[1.2.1.1.7.1.13.6.1.1]
b. 2 Oct 1831
10
Abby Jane Taft
[1.2.1.1.7.1.13.6.1.2]
b. 30 Oct 1836 d. 1906
10
Georgiana Taft
[1.2.1.1.7.1.13.6.1.3]
b. 31 Mar 1839 d. 9 Oct 1918
10
James K Polk Taft
[1.2.1.1.7.1.13.6.1.4]
b. 17 May 1847 d. 15 Sep 1847
10
Sarah Taft
[1.2.1.1.7.1.13.6.1.5]
b. 21 Sep 1852 d. 21 Sep 1852
Katharine Edwards
b. 22 Dec 1815 d. 22 Feb 1878
10
Henry Taft
[1.2.1.1.7.1.13.6.1.6]
b. 12 Nov 1854 d. 12 Nov 1854
10
Edward Taft
[1.2.1.1.7.1.13.6.1.7]
b. 7 Feb 1858 d. 9 May 1930
9
Benjamin B Taft
[1.2.1.1.7.1.13.6.2]
b. 28 Feb 1808
8
Samuel Taft
[1.2.1.1.7.1.13.7]
b. 18 Oct 1788 d. 20 Oct 1859
8
Elisha Taft
[1.2.1.1.7.1.13.8]
b. 15 Feb 1791 d. 26 Dec 1849
8
Elizabeth Taft
[1.2.1.1.7.1.13.9]
b. 2 Feb 1795
7
Phila Taft
[1.2.1.1.7.1.14]
b. Abt 1748 d. 1794
6
Jacob Aldrich
[1.2.1.1.7.2]
b. 1 Oct 1701 d. 30 Oct 1701
6
Huldah Aldrich
[1.2.1.1.7.3]
b. 29 Jan 1703 d. 1748
6
Hannah Aldrich
[1.2.1.1.7.4]
b. 3 Jun 1704 d. 18 Mar 1794
6
Experience Aldrich
[1.2.1.1.7.5]
b. 30 Dec 1708 d. Abt 1751
6
Jacob Aldrich
[1.2.1.1.7.6]
b. 29 May 1711
6
Bethiah Aldrich
[1.2.1.1.7.7]
b. 7 Mar 1713
6
Margaret Aldrich
[1.2.1.1.7.8]
b. 14 Mar 1714 d. 7 Oct 1767
6
Noah Aldrich
[1.2.1.1.7.9]
b. 28 Aug 1717 d. 1759
5
Sarah Hayward
[1.2.1.1.8]
b. 2 Mar 1676 d. 12 Aug 1712
Azrikim Pierce
b. 4 Jan 1671 d. 29 Jan 1748
6
Azrikim Pierce
[1.2.1.1.8.1]
b. 1697 d. 28 Feb 1697
6
Samuel Pierce
[1.2.1.1.8.2]
b. 17 Dec 1700 d. 1760
6
Isaac Pierce
[1.2.1.1.8.3]
b. Abt 1702 d. 1747
6
Sarah Pierce
[1.2.1.1.8.4]
b. Abt 1704 d. 23 Jul 1725
6
Benjamin Pearce
[1.2.1.1.8.5]
b. Abt 1704 d. Aft 1742
5
Hannah Hayward
[1.2.1.1.9]
b. 18 Aug 1680 d. 1746
+
Peter Aldrich
b. 19 Oct 1686 d. 1724
5
Deborah Hayward
[1.2.1.1.10]
b. 9 Nov 1682
+
Seth Aldrich
b. 6 Jul 1679 d. 15 Oct 1737
5
Samuel Hayward
[1.2.1.1.11]
b. 7 Feb 1684 d. 16 May 1708
5
Jonathan Hayward
[1.2.1.1.12]
b. 10 Oct 1686 d. 24 Nov 1751
+
Elizabeth Lee
b. 9 Sep 1670
5
Experience Hayward
[1.2.1.1.13]
b. 1 Mar 1688
5
Benjamin Hayward
[1.2.1.1.14]
b. 14 Feb 1689 d. 19 Feb 1766
5
Bethiah Hayward
[1.2.1.1.15]
b. Abt 1691
4
John Thompson, Jr
[1.2.1.2]
b. 4 Apr 1645 d. 20 Oct 1691
4
Ebenezer Thompson
[1.2.1.3]
b. 1649 d. 1650
4
Sarah Thompson
[1.2.1.4]
b. 13 Nov 1657 d. 25 Feb 1678
John Aldrich
b. 2 Apr 1644 d. 2 Apr 1685
5
Joseph Aldrich
[1.2.1.4.1]
b. 25 Sep 1676 d. 1724
5
Jacob Aldrich
[1.2.1.4.2]
b. 27 Dec 1677 d. 10 Mar 1678
4
William Thompson
[1.2.1.5]
b. Abt 1658
2
Elizabeth Bolwell
[1.3]
b. 1595
2
Marye Bolwell
[1.4]
b. 10 Sep 1598
2
William Bolwell
[1.5]
b. 1601