Home Page
|
What's New
|
Photos
|
Histories
|
Headstones
|
Reports
|
Surnames
Search
First Name:
Last Name:
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Suomalainen
Svenska
Joanna Strutt
1536 - 1577 (41 years)
Submit Photo / Document
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Submit Photo / Doc
Worksheet
Family
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Joanna Strutt
[1]
b. 1536 d. 14 Aug 1577
John Belgrave
b. 1535 d. 12 Feb 1591
2
Elizabeth Belgrave
[1.1]
b. 1558 bur. 9 Sep 1645
Thomas Josiah Gilbert
b. 15 Jun 1556 d. 7 Sep 1642
3
Elizabeth Gilbert
[1.1.1]
b. Abt 1578 d. 28 Mar 1654
Jonathan Deming
b. 18 Oct 1575 d. 8 Jan 1673
4
Elizabeth Deming
[1.1.1.1]
b. Oct 1595 d. 28 Jul 1683
Nathaniel Foote
b. 21 Sep 1592 d. 28 Jul 1644
5
Nathaniel Foote
[1.1.1.1.1]
b. 5 Mar 1619 d. Jun 1655
5
Joanna Foote
[1.1.1.1.2]
b. 10 Mar 1625 d. 14 Sep 1666
Lieutenant Joseph Kellogg
b. 1 Apr 1626 d. 4 Feb 1708
6
Nathaniel Kellogg
[1.1.1.1.2.1]
b. 29 Oct 1654 d. 30 Oct 1750
Sarah Boltwood
b. 1 Oct 1672 d. 26 Jan 1761
7
Nathaniel Kellogg
[1.1.1.1.2.1.1]
b. 22 Sep 1693 d. 6 Aug 1770
Sarah Preston
b. 8 Nov 1693 d. 15 Sep 1756
8
Daniel Kellogg
[1.1.1.1.2.1.1.1]
b. 1717 d. 14 Jan 1799
8
Abraham Kellogg
[1.1.1.1.2.1.1.2]
b. 1719 bur. 1776
8
Gardener Kellogg
[1.1.1.1.2.1.1.3]
b. 1723 d. 6 Oct 1814
8
Prudence Kellogg
[1.1.1.1.2.1.1.4]
b. 1723 d. 27 Jun 1791
8
Joel Kellogg
[1.1.1.1.2.1.1.5]
b. Abt 1728 d. 22 Oct 1798
Joanna Clark
b. 10 May 1695 d. 11 Jun 1795
9
Miriam Kellogg
[1.1.1.1.2.1.1.5.1]
b. 22 Dec 1751 d. 2 Feb 1824
9
Seth Kellogg
[1.1.1.1.2.1.1.5.2]
b. 1754 d. 30 Nov 1827
Jerusha White
b. 5 Mar 1762
10
Joel Kellogg
[1.1.1.1.2.1.1.5.2.1]
b. 24 Jan 1782 d. 24 Jan 1845
10
Oliver White Kellogg
[1.1.1.1.2.1.1.5.2.2]
b. Abt 1783 d. 24 Jan 1845
10
Jerusha Rebecca Kellogg
[1.1.1.1.2.1.1.5.2.3]
b. 15 Nov 1785 d. 23 Aug 1836
Charles Robison, Jr
b. 5 Jun 1785 d. 4 Oct 1840
11
Chauncey Robison
[1.1.1.1.2.1.1.5.2.3.1]
b. 27 Mar 1805 d. 4 Nov 1891
11
Malinda Robison
[1.1.1.1.2.1.1.5.2.3.2]
b. 11 Nov 1806 d. 16 May 1898
11
John Knapp Robison
[1.1.1.1.2.1.1.5.2.3.3]
b. 2 Oct 1808 d. 27 Jan 1887
11
James Robison
[1.1.1.1.2.1.1.5.2.3.4]
b. 11 Sep 1810 d. 20 Apr 1841
11
William Robison
[1.1.1.1.2.1.1.5.2.3.5]
b. 4 Oct 1812 d. 10 Oct 1812
11
Lucinda Robison
[1.1.1.1.2.1.1.5.2.3.6]
b. 20 Jul 1814 d. 14 May 1893
11
Lewis Robison
[1.1.1.1.2.1.1.5.2.3.7]
b. 28 Oct 1816 d. 1 Nov 1883
Clarissa Minerva Duzette
b. 18 Dec 1822 d. 21 Oct 1891
12
James Madison Robison
[1.1.1.1.2.1.1.5.2.3.7.1]
b. 8 Aug 1841 d. 14 Jun 1842
12
Solon Wells Robison
[1.1.1.1.2.1.1.5.2.3.7.2]
b. 10 Apr 1843 d. 12 Dec 1925
12
Charles Edward Robison
[1.1.1.1.2.1.1.5.2.3.7.3]
b. 2 Dec 1845 d. 26 Sep 1883 [
=>
]
12
Lewis Duzette Robison
[1.1.1.1.2.1.1.5.2.3.7.4]
b. 13 Jun 1848 d. 8 May 1879
12
John Albert Robison
[1.1.1.1.2.1.1.5.2.3.7.5]
b. 29 Jul 1850 d. 29 Oct 1935
12
Clarissa Eliza Robison
[1.1.1.1.2.1.1.5.2.3.7.6]
b. 30 Mar 1854 d. 3 Jun 1937
12
Maria Mary Robison
[1.1.1.1.2.1.1.5.2.3.7.7]
b. 15 Oct 1855 d. 26 Jul 1911
12
Annie Louise Robison
[1.1.1.1.2.1.1.5.2.3.7.8]
b. 30 Oct 1857 d. 27 Feb 1939
12
Joseph Smith Robison
[1.1.1.1.2.1.1.5.2.3.7.9]
b. 10 Jan 1860 d. 10 Jan 1944
12
Irene Elizabeth Robison
[1.1.1.1.2.1.1.5.2.3.7.10]
b. 16 Jun 1862 d. 26 Nov 1946
Mary Jane Waite
b. 12 Jan 1836 d. 18 Mar 1922
12
Seth Milton Robison
[1.1.1.1.2.1.1.5.2.3.7.11]
b. 11 May 1857 d. 31 Dec 1896
12
Minerva Rebecca Robison
[1.1.1.1.2.1.1.5.2.3.7.12]
b. 19 Jul 1860 d. 23 Dec 1862
12
Emma Lenora Robison
[1.1.1.1.2.1.1.5.2.3.7.13]
b. 11 Oct 1862 d. 9 Aug 1906
12
Daniel Hanmer Robison
[1.1.1.1.2.1.1.5.2.3.7.14]
b. 28 Apr 1865 d. 27 Dec 1924
12
Inez Melissa Robison
[1.1.1.1.2.1.1.5.2.3.7.15]
b. 30 May 1868 d. 11 Feb 1945
12
Guy Kellogg Robison
[1.1.1.1.2.1.1.5.2.3.7.16]
b. 3 Apr 1871 d. 6 Sep 1948
+
Achsah Melissa Allred
b. 6 Oct 1824 d. 28 Sep 1901
Louisa R Gheen
b. 28 May 1843 d. 15 Oct 1932
12
Ellen Aseneth Robison
[1.1.1.1.2.1.1.5.2.3.7.17]
b. 18 Oct 1860 d. 16 Apr 1861
12
William Gheen Robison
[1.1.1.1.2.1.1.5.2.3.7.18]
b. 4 Apr 1865 d. 7 Oct 1865
12
May Jerusha Robison
[1.1.1.1.2.1.1.5.2.3.7.19]
b. 25 Jan 1867 d. 21 Sep 1956
12
Lydia Manette Robison
[1.1.1.1.2.1.1.5.2.3.7.20]
b. 9 Jun 1868 d. 20 Oct 1953
12
Nellie Isola Robison
[1.1.1.1.2.1.1.5.2.3.7.21]
b. 24 Nov 1871 d. 19 Apr 1949
12
Rose Drucilla Robison
[1.1.1.1.2.1.1.5.2.3.7.22]
b. 25 Oct 1873 d. 22 Apr 1921
12
Georgia Louisa Robison
[1.1.1.1.2.1.1.5.2.3.7.23]
b. Oct 1875 d. 1 Mar 1877
11
Sarah Maria Robison
[1.1.1.1.2.1.1.5.2.3.8]
b. 10 Jan 1819 d. 24 Jul 1906
11
Eliza Rebecca Robison
[1.1.1.1.2.1.1.5.2.3.9]
b. 4 Jan 1820 d. 2 Aug 1905
11
Julia Ann Robison
[1.1.1.1.2.1.1.5.2.3.10]
b. 14 Feb 1822 d. 30 Jan 1912
11
Charles Robison
[1.1.1.1.2.1.1.5.2.3.11]
b. 15 Feb 1824 d. 29 Dec 1888
11
Seth Kellogg Robison
[1.1.1.1.2.1.1.5.2.3.12]
b. 7 Dec 1827 d. 14 Feb 1910
10
Orange Kellogg
[1.1.1.1.2.1.1.5.2.4]
b. Abt 1787 d. 2 Apr 1852
10
Samuel Kellogg
[1.1.1.1.2.1.1.5.2.5]
b. Abt 1791 d. 1842
10
Elijah Walley Kellogg
[1.1.1.1.2.1.1.5.2.6]
b. 26 Oct 1792 d. 21 Nov 1835
10
Lucinda Kellogg
[1.1.1.1.2.1.1.5.2.7]
b. 1795
10
Clarissa Kellogg
[1.1.1.1.2.1.1.5.2.8]
b. 1797 d. Abt 1815
10
Joseph Kellogg
[1.1.1.1.2.1.1.5.2.9]
b. 26 Oct 1799 d. 9 May 1876
10
Levi Kellogg
[1.1.1.1.2.1.1.5.2.10]
b. 1801
10
David Kellogg
[1.1.1.1.2.1.1.5.2.11]
b. Abt 1803
10
Lucretia Kellogg
[1.1.1.1.2.1.1.5.2.12]
b. 1805
9
Joanna Kellogg
[1.1.1.1.2.1.1.5.3]
b. Abt 1755 d. 28 May 1816
9
Abigail Kellogg
[1.1.1.1.2.1.1.5.4]
b. 18 Nov 1757 d. 8 Jan 1833
9
Levi Kellogg
[1.1.1.1.2.1.1.5.5]
b. 3 Oct 1760 d. 3 Jan 1848
8
Moses Kellogg
[1.1.1.1.2.1.1.6]
b. 1733 d. 28 May 1815
8
Phoebe Kellogg
[1.1.1.1.2.1.1.7]
b. 9 Nov 1734 d. Abt 1777
7
Ebenezer Kellogg
[1.1.1.1.2.1.2]
b. 31 May 1695 d. 17 Aug 1766
7
Ezekiel Kellogg
[1.1.1.1.2.1.3]
b. 15 Apr 1697 d. Abt 1753
7
Sarah Kellogg
[1.1.1.1.2.1.4]
b. 12 Mar 1701 d. 22 Mar 1743
7
Abigail Kellogg
[1.1.1.1.2.1.5]
b. 19 Mar 1703 d. 10 Sep 1756
7
Mary Kellogg
[1.1.1.1.2.1.6]
b. 9 Mar 1706 d. 29 Dec 1788
7
Ephraim Kellogg
[1.1.1.1.2.1.7]
b. 2 Aug 1709 d. 16 Mar 1777
7
Experience Kellogg
[1.1.1.1.2.1.8]
b. 1711
6
Samuel Kellogg
[1.1.1.1.2.2]
b. 28 Sep 1662 d. 1717
6
Joanna Kellogg
[1.1.1.1.2.3]
b. 8 Dec 1664 d. 16 Apr 1727
5
Robert Foote
[1.1.1.1.3]
b. 8 Dec 1627 d. 1681
5
Frances Foote
[1.1.1.1.4]
b. 1629 d. 3 Feb 1678
5
Sarah Foote
[1.1.1.1.5]
b. 12 Feb 1631 d. 26 Mar 1704
Josiah Judson
b. 1622
6
Isaac Judson
[1.1.1.1.5.1]
b. 10 Mar 1653 d. 1687
6
Mary Judson
[1.1.1.1.5.2]
b. 31 Dec 1655
6
Elizabeth Judson
[1.1.1.1.5.3]
b. 24 Feb 1657 d. Abt 1691
6
Sarah Judson
[1.1.1.1.5.4]
b. 7 Apr 1662
6
Mercy Judson
[1.1.1.1.5.5]
b. 14 Jun 1665 d. Abt 1736
6
Jeremiah Judson
[1.1.1.1.5.6]
b. 1 Mar 1670 d. 9 Feb 1734
Mary Welles
b. 29 Nov 1670 d. Bef 11 Oct 1751
7
Eunice Judson
[1.1.1.1.5.6.1]
b. 1695
Nathaniel Curtis
b. 21 Feb 1690
8
Jeremia Judson Curtis
[1.1.1.1.5.6.1.1]
b. 4 Apr 1716 d. 4 Sep 1782
8
Mary Curtis
[1.1.1.1.5.6.1.2]
b. 28 Aug 1717 d. 18 Dec 1781
Nathaniel Curtis
b. Abt 1716 d. 1791
9
Abigail Curtis
[1.1.1.1.5.6.1.2.1]
b. 17 Mar 1742 d. May 1820
Samuel Tiffany
b. 13 Jul 1740 d. Mar 1822
10
Samuel Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.1]
b. 21 Oct 1761 d. 21 Apr 1851
Mary Sackett
b. Abt 1761 d. 1862
11
Samuel Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.1.1]
b. 1788 d. Abt 1845
11
Mary Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.1.2]
b. 1797
11
Julia Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.1.3]
b. 1799 d. 13 Jan 1891
11
Thomas Jefferson Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.1.4]
b. 1801
11
Hannah Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.1.5]
b. 5 Apr 1804 d. 10 Sep 1860
11
Calinda Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.1.6]
b. 2 Dec 1807 d. 5 Mar 1866
11
Ezekiel Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.1.7]
b. 1810
11
Jefferson Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.1.8]
b. Abt 1810
11
Harry Edward Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.1.9]
b. 25 Jun 1813 d. 14 Dec 1871
11
Harriet Emeline Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.1.10]
b. Abt 1815
11
Lorenzo Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.1.11]
b. Abt 1818
10
Nathanial Curtis Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.2]
b. 18 Feb 1762 d. 13 Feb 1857
Dency Crane
b. Abt 1765
11
Nathaniel Curtis Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.2.1]
b. Mar 1790
11
Harriet Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.2.2]
b. Mar 1792 d. 1858
11
Dancy Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.2.3]
b. 25 Sep 1795 d. 24 Mar 1846
11
Anron Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.2.4]
b. 2 Jun 1797 d. 27 Feb 1847
11
Betsey Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.2.5]
b. Abt 1799
11
David Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.2.6]
b. 1800
11
Mary Polly Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.2.7]
b. 17 Dec 1801 d. 20 May 1835
11
Elizabeth Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.2.8]
b. 1805
11
Caroline Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.2.9]
b. Abt 1807 d. 1843
10
Jemima Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.3]
b. 1763 d. 6 Mar 1848
Reuben Ward
b. 13 Nov 1748 d. 5 Jul 1825
11
Affa Ward
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.3.1]
b. 27 May 1783 d. 28 Feb 1877
William Stilson
b. 23 Sep 1783 d. 4 May 1862
12
Caroline Stilson
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.3.1.1]
b. 20 Jan 1808 d. 12 Jan 1883
12
Albert Stilson
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.3.1.2]
b. 16 Jan 1810 d. 30 Sep 1895
12
Celinda Stilson
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.3.1.3]
b. 4 Feb 1811 d. 26 Jun 1845
12
Emeline Stilson
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.3.1.4]
b. 27 Sep 1813 d. 6 Jan 1887
12
William M Stilson
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.3.1.5]
b. 2 Apr 1816
12
Saphronia Stilson
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.3.1.6]
b. 3 Nov 1817 d. 6 Jan 1887
12
Minor Stilson
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.3.1.7]
b. 9 Jan 1821
12
Affa C Stilson
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.3.1.8]
b. 31 Mar 1823 d. Abt 1879
12
Rueben R Stilson
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.3.1.9]
b. 29 Dec 1824
12
Allen Stilson
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.3.1.10]
b. 12 Apr 1827 d. 25 Jan 1878
11
Reuben Ward
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.3.2]
b. Abt 1784 d. 5 Mar 1876
11
Jemima Ward
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.3.3]
b. Abt 1786
11
Laura Ward
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.3.4]
b. Abt 1790
11
Eda Ward
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.3.5]
b. Abt 1788
11
Samuel Ward
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.3.6]
b. Abt 1792 d. 23 Feb 1873
11
Dorcas Ward
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.3.7]
b. Abt 1794
11
Cynthia Ward
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.3.8]
b. Abt 1796
+
Henry Rolluff
b. Abt 1782
11
William B Ward
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.3.9]
b. 1801
11
Daniel Ward
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.3.10]
b. 1807
10
William Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.4]
b. Abt 1765
10
Emellason Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.5]
b. Abt 1765 d. 18 Mar 1847
Sarah Aldrich
b. 4 Apr 1773
11
Rhoda Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.5.1]
b. 1 Nov 1793
11
George Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.5.2]
b. 5 May 1794
11
Lemuel Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.5.3]
b. 30 Jun 1796
11
David Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.5.4]
b. 18 Aug 1798
11
Sarah Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.5.5]
b. 27 Mar 1803 d. 14 Nov 1838
11
Silas Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.5.6]
b. 13 Apr 1809
10
Daniel Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.6]
b. 18 Sep 1768 d. 25 Sep 1793
+
Phebe Rand
b. Abt 1770
10
Abigail Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.7]
b. Abt 1770
+
Zenos Aldrich
b. 1766 d. 8 Nov 1856
10
George Obediah Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.8]
b. 7 May 1772 d. 13 Feb 1857
Mary Mason
b. Abt 1766 d. 16 Mar 1840
11
Abigail Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.8.1]
b. Abt 1797 d. Dec 1859
11
Zilpha Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.8.2]
b. Abt 1799 d. 1830
11
Zenas Schovil Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.8.3]
b. 25 Jun 1801 d. 1822
11
Luther Little Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.8.4]
b. 28 Mar 1803 d. 17 Feb 1881
11
Frederick Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.8.5]
b. 1804 d. 1804
11
Lorenzo Mason Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.8.6]
b. Abt 1804 d. Abt 1809
11
Jane Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.8.7]
b. 14 Apr 1805 d. 26 Nov 1867
11
George Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.8.8]
b. 4 May 1808 d. 21 Jun 1885
Almira Whipple
b. 13 Jun 1810 d. 4 Feb 1889
12
Cynthia Jane Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.8.8.1]
b. 2 Feb 1830 d. 6 Oct 1845
12
Zenos Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.8.8.2]
b. 21 Jul 1831 d. Dec 1843
12
Ira Patchen Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.8.8.3]
b. 14 Feb 1835 d. 21 Mar 1905 [
=>
]
12
Loyal Peck Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.8.8.4]
b. 27 Jul 1837 d. 15 Feb 1903
12
Mary Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.8.8.5]
b. 18 Dec 1844 d. 14 Dec 1845
12
Almira Rebecca Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.8.8.6]
b. 18 Aug 1847 d. 23 Nov 1914 [
=>
]
12
George Mason Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.8.8.7]
b. 31 Jan 1850 d. 14 Mar 1909 [
=>
]
12
Nelson Whipple Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.8.8.8]
b. 6 Aug 1852 d. 20 Jan 1927 [
=>
]
11
Lorenzo Roderick Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.8.9]
b. 4 Jul 1810 d. Abt 1810
11
Richard Mason Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.8.10]
b. 4 Jul 1810 d. 1897
11
Daniel Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.8.11]
b. 12 Sep 1812 d. 25 Jan 1894
11
Mary Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.8.12]
b. 28 Mar 1814 d. 1899
11
Phebe Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.8.13]
b. 24 Oct 1817 d. 20 Feb 1850
11
Larena Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.8.14]
b. 1818 d. 1844
11
Ann Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.8.15]
b. 4 Jun 1822 d. 12 Sep 1893
10
Mary Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9]
b. 17 Jun 1777 d. 12 Sep 1845
Daniel Whipple
b. 27 Aug 1779 d. 27 Sep 1839
11
Cynthia Whipple
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.1]
b. 15 Jan 1805 d. 1889
Ezra Gray
b. 1793 d. 1870
12
Hiram T Gray
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.1.1]
b. 25 Aug 1832 d. 30 Jun 1875
12
Daniel William Gray
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.1.2]
b. 19 May 1834 d. 9 Dec 1890 [
=>
]
12
Daughter Gray
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.1.3]
b. 1834
12
Emily Jane Gray
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.1.4]
b. 14 Nov 1837 d. 13 Feb 1908
12
Betsey T Gray
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.1.5]
b. 1840
12
Mary M Gray
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.1.6]
b. 1844
12
George W Gray
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.1.7]
b. 1846 d. 4 Aug 1918 [
=>
]
11
Samuel Whipple
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.2]
b. 21 Dec 1808 d. 9 Jan 1887
Phoebe Kingsbury
b. 14 Dec 1812 d. 24 Apr 1851
12
Sabrina Whipple
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.2.1]
b. 30 Mar 1832 d. 1920
12
George T Whipple
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.2.2]
b. 4 Dec 1833 d. 28 Aug 1868
12
Polly Whipple
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.2.3]
b. 4 Jun 1835 d. 24 Mar 1855
12
Daniel Whipple
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.2.4]
b. 21 Jun 1837
12
Margaret Whipple
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.2.5]
b. 18 Jun 1839 d. 8 Oct 1840
12
Mason Kingsbury Whipple
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.2.6]
b. 17 Feb 1842 d. 27 Mar 1919 [
=>
]
12
Samuel Whipple
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.2.7]
b. 4 Mar 1844 d. May 1924
12
Hassett Whipple
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.2.8]
b. 20 Feb 1846 d. 3 Jan 1852
12
Almira Whipple
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.2.9]
b. 21 Apr 1848 d. 22 Sep 1911
12
Cynthia Whipple
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.2.10]
b. 10 Nov 1850 d. 17 Apr 1851
11
Almira Whipple
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.3]
b. 13 Jun 1810 d. 4 Feb 1889
George Tiffany
b. 4 May 1808 d. 21 Jun 1885
12
Cynthia Jane Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.3.1]
b. 2 Feb 1830 d. 6 Oct 1845
12
Zenos Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.3.2]
b. 21 Jul 1831 d. Dec 1843
12
Ira Patchen Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.3.3]
b. 14 Feb 1835 d. 21 Mar 1905 [
=>
]
12
Loyal Peck Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.3.4]
b. 27 Jul 1837 d. 15 Feb 1903
12
Mary Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.3.5]
b. 18 Dec 1844 d. 14 Dec 1845
12
Almira Rebecca Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.3.6]
b. 18 Aug 1847 d. 23 Nov 1914 [
=>
]
12
George Mason Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.3.7]
b. 31 Jan 1850 d. 14 Mar 1909 [
=>
]
12
Nelson Whipple Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.3.8]
b. 6 Aug 1852 d. 20 Jan 1927 [
=>
]
11
Phoebe Whipple
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.4]
b. 13 Aug 1813 d. 18 Nov 1846
Benjamin Bengraw Shaw
b. 1808
12
Clymenia Azuba Shaw
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.4.1]
b. 2 Feb 1834 d. 10 Aug 1920 [
=>
]
Benjamin Gibson
b. 9 May 1805 d. 26 Nov 1897
12
Hannah Gibson
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.4.2]
b. 24 Apr 1836 d. 31 Oct 1846
12
Isabella Amy Gibson
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.4.3]
b. 20 Mar 1838 d. 11 Feb 1898 [
=>
]
12
Mary Jane Gibson
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.4.4]
b. 5 Feb 1840 d. 12 Jun 1912 [
=>
]
12
Susan Jane Gibson
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.4.5]
b. 11 Oct 1842 d. 25 May 1929 [
=>
]
12
Jemima Gibson
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.4.6]
b. 1847
11
Carum Whipple
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.5]
b. 12 Aug 1815 d. 1843
11
Gerua Whipple
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.6]
b. 12 Aug 1815 d. 18 Sep 1848
11
Nelson Wheeler Whipple
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.7]
b. 11 Jul 1818 d. 5 Jul 1887
Susan Jane Bailey
b. 9 Mar 1828 d. 5 Jun 1856
12
Son Whipple
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.7.1]
b. 15 Oct 1844 d. 15 Oct 1844
12
Miranda Jane Whipple
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.7.2]
b. 14 Mar 1847 d. 29 Dec 1907 [
=>
]
12
Mary Janet Whipple
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.7.3]
b. 14 Feb 1849 d. Nov 1922 [
=>
]
12
George Nelson Whipple
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.7.4]
b. 20 Mar 1851 d. 8 Jun 1912 [
=>
]
12
Edson Whipple
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.7.5]
b. 10 Oct 1853 d. 26 Feb 1909 [
=>
]
12
Harriet Emily Whipple
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.7.6]
b. 21 Nov 1855 d. 4 Oct 1856
12
Annie Bard Whipple
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.7.7]
b. 5 Jun 1856
Susan Ann Gay
b. 13 Jun 1841 d. 29 Sep 1911
12
Martha Ellen Whipple
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.7.8]
b. 19 Jan 1858 d. 20 Oct 1937 [
=>
]
12
Nelson Gay Whipple
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.7.9]
b. 21 Sep 1859 d. 2 Apr 1944 [
=>
]
12
Sylvia Gay Whipple
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.7.10]
b. 18 May 1862 d. 20 Jan 1940 [
=>
]
12
Susan Ann Whipple
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.7.11]
b. 3 Nov 1864 d. 19 Dec 1935 [
=>
]
12
Alexander Samuel Whipple
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.7.12]
b. 2 Mar 1867 d. 8 Jan 1899 [
=>
]
12
Robert John Whipple
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.7.13]
b. 13 Nov 1869 d. 6 Nov 1954 [
=>
]
12
Amey Jane Whipple
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.7.14]
b. 15 Dec 1871 d. 6 Sep 1962 [
=>
]
12
Ida Whipple
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.7.15]
b. 15 Dec 1873 d. 21 May 1956 [
=>
]
12
Anor Whipple
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.7.16]
b. 25 Mar 1879 d. 23 Oct 1967 [
=>
]
Rachel Keeling
b. 10 Mar 1818 d. 16 Jun 1910
12
Daniel Whipple
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.7.17]
b. 12 Apr 1854 d. 12 Feb 1926 [
=>
]
12
Cynthia Delight Whipple
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.7.18]
b. 7 Jun 1857 d. 4 Sep 1858
12
Nelson Wheeler Whipple, Jr
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.7.19]
b. 15 Apr 1859 d. 30 Jun 1938 [
=>
]
Zenos Aldrich
b. Abt 1773 d. 8 Nov 1856
11
Sylvanus Aldrich
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.8]
b. 1799 d. 8 Nov 1856
11
Azuba Aldrich
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.9]
b. Abt 1801
Armstrong Baskins
b. 3 Apr 1786 d. 27 May 1842
12
Sarah Ann Baskins
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.9.1]
b. Abt 1824
12
Harriet N Baskins
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.9.2]
b. Abt 1830
12
Mary Jane Baskins
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.9.3]
b. 1832 d. 22 Dec 1850
12
Erastus Baskins
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.9.9.4]
b. 1834 d. 3 Nov 1862
10
Azuba Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.10]
b. 22 Aug 1779 d. 13 Nov 1865
Jared Patchen
b. 5 Sep 1773 d. 1 May 1857
11
Martin Ray Patchen
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.10.1]
b. 10 Feb 1799 d. 7 Feb 1842
11
Abigail Patchen
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.10.2]
b. 23 Jan 1801 d. 7 Sep 1823
11
Emily Patchen
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.10.3]
b. 1802 d. 16 Jul 1826
11
John Patchen
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.10.4]
b. 14 Jan 1803 d. 23 Oct 1874
11
Ira Patchen
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.10.5]
b. 10 Jun 1805
11
Polly Patchen
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.10.6]
b. 20 Jan 1808 d. 21 Aug 1891
11
Mary Patchen
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.10.7]
b. 20 Jan 1808 d. 23 Feb 1888
11
Jared Patchen
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.10.8]
b. 6 Sep 1812
11
Sylvanus Aldridge Patchen
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.10.9]
b. 27 Nov 1814 d. 10 Feb 1892
11
Azuba Ann Patchen
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.10.10]
b. 4 Jun 1817 d. 29 Sep 1886
11
Hannah Lavinia Patchen
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.10.11]
b. 24 Apr 1820
11
Samuel Lorenzo Patchen
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.10.12]
b. 1 Aug 1823 d. 14 Jun 1867
11
Amy Patchen
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.10.13]
b. Abt 5 Jul 1825
10
Phoebe Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.11]
b. 22 Aug 1781 d. 31 Dec 1855
Nathan S Stewart
b. 7 Mar 1771 d. 7 Aug 1866
11
Horace S Stewart
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.11.1]
b. 15 Jun 1804 d. 7 Aug 1866
11
Erastus A Stewart
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.11.2]
b. 10 Mar 1805 d. 10 Nov 1851
11
Elijah Burr Stewart
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.11.3]
b. Abt 1809 d. 9 Nov 1880
11
Azuba Ann Stewart
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.11.4]
b. 1810
11
Samuel Curtis Stewart
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.11.5]
b. 1811 d. 25 Nov 1870
11
William Stewart
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.11.6]
b. 1812
11
Azubam Stewart
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.11.7]
b. 1812
11
Thomas Ryler Stewart
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.11.8]
b. 1815
10
Amy Tiffany
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.12]
b. 8 Dec 1783 d. 17 Dec 1857
Isaac Darrow
b. Abt 1779
11
John Tiffany Darrow
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.12.1]
b. 17 Nov 1800 d. 13 Nov 1897
11
Affa Ward Darrow
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.12.2]
b. 26 Dec 1803 d. 15 Apr 1875
11
Hannah Mead Darrow
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.12.3]
b. 24 Apr 1806
11
Mary Cromwell Darrow
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.12.4]
b. 9 May 1808 d. 18 Nov 1877
11
Ann Hubbard Darrow
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.12.5]
b. 27 Mar 1811 d. 24 Jul 1890
11
Susan Pardee Darrow
[1.1.1.1.5.6.1.2.1.12.6]
b. 1813 d. 24 Jun 1890
9
Zachariah Curtis
[1.1.1.1.5.6.1.2.2]
b. 1745
Sarah
b. 1749
10
Mary Curtis
[1.1.1.1.5.6.1.2.2.1]
c. 18 Aug 1771
10
James Curtis
[1.1.1.1.5.6.1.2.2.2]
c. 9 Apr 1773
10
Ann Curtis
[1.1.1.1.5.6.1.2.2.3]
c. 15 May 1775
10
Sarah Curtis
[1.1.1.1.5.6.1.2.2.4]
c. 2 Mar 1777
10
Hannah Curtis
[1.1.1.1.5.6.1.2.2.5]
c. 14 Feb 1778 d. 20 Feb 1778
10
Esther Curtis
[1.1.1.1.5.6.1.2.2.6]
c. 14 Feb 1778 d. 18 Jan 1779
10
Zachariah Curtis
[1.1.1.1.5.6.1.2.2.7]
c. 5 Aug 1781 d. 28 Jul 1782
9
Thomas Curtis
[1.1.1.1.5.6.1.2.3]
b. 1748 d. 26 Nov 1823
Eunice Peet
b. Nov 1771 d. Abt 1835
10
Charles Curtis
[1.1.1.1.5.6.1.2.3.1]
b. 1791
10
Ira Curtis
[1.1.1.1.5.6.1.2.3.2]
b. 15 Mar 1794
10
Philip Curtis
[1.1.1.1.5.6.1.2.3.3]
b. 1795
10
Son Curtis
[1.1.1.1.5.6.1.2.3.4]
b. 23 May 1798 d. 23 May 1798
10
William K Curtis
[1.1.1.1.5.6.1.2.3.5]
b. 22 Dec 1800 d. 1 Mar 1873
10
Elizabeth Curtis
[1.1.1.1.5.6.1.2.3.6]
b. 27 Nov 1803 d. 13 Jan 1853
10
Amos Curtis
[1.1.1.1.5.6.1.2.3.7]
b. Abt 1804
10
Huldah Jane Curtis
[1.1.1.1.5.6.1.2.3.8]
b. 22 Jul 1805 d. 25 Nov 1887
10
Thomas Curtis
[1.1.1.1.5.6.1.2.3.9]
b. Abt 1806
9
Charity Curtis
[1.1.1.1.5.6.1.2.4]
b. 1750 d. 25 Mar 1820
9
Nathaniel Curtis
[1.1.1.1.5.6.1.2.5]
b. 1755
9
Andrew Curtis
[1.1.1.1.5.6.1.2.6]
b. 18 Jul 1756 d. 5 Nov 1834
Eunice Hall
b. 4 Mar 1770 d. 4 Mar 1839
10
Hull Curtis
[1.1.1.1.5.6.1.2.6.1]
b. 16 May 1797
10
Miranda Curtis
[1.1.1.1.5.6.1.2.6.2]
b. 12 Jul 1799 d. 23 Apr 1877
9
Everard Curtis
[1.1.1.1.5.6.1.2.7]
b. 8 Dec 1758 d. 5 Jul 1846
Clarissa Peet
b. Abt 1772 d. 7 Apr 1827
10
Clarissa Curtis
[1.1.1.1.5.6.1.2.7.1]
b. Abt 1801
10
Anson Curtis
[1.1.1.1.5.6.1.2.7.2]
b. Abt 1803 d. 1847
10
Charles Curtis
[1.1.1.1.5.6.1.2.7.3]
b. 8 Oct 1805 d. 8 Mar 1880
8
Eunice Curtis
[1.1.1.1.5.6.1.3]
b. 11 Nov 1719 d. 1803
8
Nathaniel Curtis, Jr
[1.1.1.1.5.6.1.4]
b. Abt 1720 d. 1776
8
Anna Curtis
[1.1.1.1.5.6.1.5]
b. Abt 1722 d. Bef 12 Mar 1761
8
Judson Curtis
[1.1.1.1.5.6.1.6]
b. 22 May 1723 d. 23 Mar 1808
8
Charity Curtis
[1.1.1.1.5.6.1.7]
b. Abt 1726 d. 5 Aug 1773
8
Phebe Curtis
[1.1.1.1.5.6.1.8]
5
Rebecca Foote
[1.1.1.1.6]
b. 3 Sep 1634 d. 6 Apr 1701
Lieutenant Philip Smith
b. 30 Apr 1632 d. 10 Jan 1685
6
Charles Smith
[1.1.1.1.6.1]
b. 2 Jan 1661 d. 22 Jan 1661
6
Deacon John Smith
[1.1.1.1.6.2]
b. 18 Dec 1661 d. 16 Apr 1727
6
Jonathan Smith
[1.1.1.1.6.3]
b. Abt 18 Dec 1663 d. Abt 9 Oct 1737
6
Philip Smith
[1.1.1.1.6.4]
b. 1665 d. 25 Jan 1725
Mary Bliss
b. 14 Aug 1670 d. 23 Dec 1707
7
Philip Smith
[1.1.1.1.6.4.1]
b. 1 May 1689 d. 1712
7
David Smith
[1.1.1.1.6.4.2]
b. 23 Apr 1691
7
Martha Smith
[1.1.1.1.6.4.3]
b. 27 Sep 1694 d. 1750
7
Samuel Smith
[1.1.1.1.6.4.4]
b. Abt 1696 d. 28 Aug 1777
7
Aaron Smith
[1.1.1.1.6.4.5]
b. 14 Feb 1697
7
Mary Smith
[1.1.1.1.6.4.6]
b. 23 Feb 1699 d. Aft 1774
7
Samuel Smith
[1.1.1.1.6.4.7]
b. 10 Dec 1701
7
Rebecca Smith
[1.1.1.1.6.4.8]
b. 18 Apr 1705 d. 3 Feb 1788
7
Ebenezer Smith
[1.1.1.1.6.4.9]
b. 1 Jan 1707
7
Nehemiah Smith
[1.1.1.1.6.4.10]
b. 17 Jul 1709 d. 1745
6
Rebecca Smith
[1.1.1.1.6.5]
b. 1668 d. 7 Oct 1750
6
Nathanial Smith
[1.1.1.1.6.6]
b. 1671 d. 1740
6
Joseph Smith
[1.1.1.1.6.7]
b. 1674 d. 8 Sep 1736
4
Martha Deming
[1.1.1.2]
b. 1606
4
John Deming
[1.1.1.3]
b. 1615 d. 21 Nov 1705
Honor Treat
b. 19 Mar 1615 d. 21 Nov 1705
5
Sarah Deming
[1.1.1.3.1]
b. Abt 1634 d. 29 Sep 1717
5
Johnathan Deming
[1.1.1.3.2]
b. 9 Sep 1638 d. 23 Jan 1712
5
Rachel Deming
[1.1.1.3.3]
b. 1644 d. 2 Jun 1712
Captain John Morgan
b. 30 Mar 1645 d. 12 Feb 1712
6
James Morgan
[1.1.1.3.3.1]
b. 6 Feb 1667 d. Bef 7 Nov 1721
6
John Morgan, Jr
[1.1.1.3.3.2]
b. 10 Jun 1667 d. 16 Mar 1746
6
Samuel Morgan
[1.1.1.3.3.3]
b. 9 Sep 1669 d. 1729
6
Isaac Morgan
[1.1.1.3.3.4]
b. 24 Oct 1670 d. 25 Nov 1754
Mary Spalding
b. 8 Sep 1675 d. 30 Apr 1735
7
Beniamin Morgan
[1.1.1.3.3.4.1]
b. Abt 1700
7
David Morgan
[1.1.1.3.3.4.2]
b. 21 Feb 1700 d. 24 Mar 1768
Dorothy Lamb
b. 1708 d. 26 Aug 1804
8
Isaac Morgan
[1.1.1.3.3.4.2.1]
b. 26 Apr 1730 d. 2 Nov 1815
Zilpha Meech
b. 27 Nov 1734 d. 19 Jan 1763
9
Nathan Morgan
[1.1.1.3.3.4.2.1.1]
b. 15 Sep 1753
9
Mary Morgan
[1.1.1.3.3.4.2.1.2]
b. 10 Dec 1755
Joshua Grant, Jr
b. 1755 d. 30 Jan 1826
10
Joshua Grant, III
[1.1.1.3.3.4.2.1.2.1]
b. 5 Mar 1778 d. 7 Jan 1865
Athalia "Thalia" Howard
b. 21 Aug 1786 d. 4 Jun 1853
11
Joseph Grant
[1.1.1.3.3.4.2.1.2.1.1]
b. 27 Sep 1805 d. 25 Dec 1859
11
Lois Grant
[1.1.1.3.3.4.2.1.2.1.2]
b. 3 Aug 1807 d. 14 Aug 1867
11
Austin Gillette Grant
[1.1.1.3.3.4.2.1.2.1.3]
b. 30 Dec 1808 d. 30 Aug 1895
11
Nelson Grant
[1.1.1.3.3.4.2.1.2.1.4]
b. 16 Feb 1810 d. 27 Feb 1892
11
George Davis Grant
[1.1.1.3.3.4.2.1.2.1.5]
b. 10 Sep 1812 d. 20 Sep 1876
+
Rachel Ridgeway Ivins
b. 9 Mar 1821 d. 27 Jun 1909
11
Carolina Amanda Grant
[1.1.1.3.3.4.2.1.2.1.6]
b. 22 Jan 1814 d. 22 May 1845
William B Smith
b. 13 Mar 1811 d. 13 Nov 1893
12
Mary Jane Smith
[1.1.1.3.3.4.2.1.2.1.6.1]
b. 7 Jan 1834 d. 21 Dec 1878
12
Caroline L Smith
[1.1.1.3.3.4.2.1.2.1.6.2]
b. Aug 1839 d. 9 Jan 1878
11
Jedediah Morgan Grant
[1.1.1.3.3.4.2.1.2.1.7]
b. 21 Feb 1816 bur. 4 Dec 1856
Rachel Ridgeway Ivins
b. 9 Mar 1821 d. 27 Jun 1909
12
Heber Jeddy Grant
[1.1.1.3.3.4.2.1.2.1.7.1]
b. 22 Nov 1856 d. 14 May 1945 [
=>
]
11
Joshua Frederick Grant
[1.1.1.3.3.4.2.1.2.1.8]
b. 24 Jul 1818 d. 21 Nov 1851
11
Theda C Grant
[1.1.1.3.3.4.2.1.2.1.9]
b. 13 Apr 1821 d. 13 May 1909
11
Thomas Jefferson Grant
[1.1.1.3.3.4.2.1.2.1.10]
b. 10 Jun 1823 d. 23 Feb 1899
11
Roxie Ann Grant
[1.1.1.3.3.4.2.1.2.1.11]
b. 16 Mar 1825 d. 30 Mar 1900
William B Smith
b. 13 Mar 1811 d. 13 Nov 1893
12
Thalia Grant Smith
[1.1.1.3.3.4.2.1.2.1.11.1]
b. 21 Sep 1848 d. 27 Nov 1924
12
Hyrum Wallace Smith
[1.1.1.3.3.4.2.1.2.1.11.2]
b. 17 Aug 1850 d. 27 Jan 1935
11
Howard Grant
[1.1.1.3.3.4.2.1.2.1.12]
b. 4 May 1827 d. 16 Feb 1859
10
Thomas Grant
[1.1.1.3.3.4.2.1.2.2]
b. Abt 1780
10
Abigail Grant
[1.1.1.3.3.4.2.1.2.3]
b. Abt 1782
10
Morgan Grant
[1.1.1.3.3.4.2.1.2.4]
b. Abt 1784
10
Lois Grant
[1.1.1.3.3.4.2.1.2.5]
b. 1786 d. 15 Jan 1834
10
Susan Grant
[1.1.1.3.3.4.2.1.2.6]
b. Abt 1788
9
Anna Morgan
[1.1.1.3.3.4.2.1.3]
b. 1 Mar 1758 d. 1773
8
Mary Morgan
[1.1.1.3.3.4.2.2]
b. 27 Apr 1732 d. 9 Jun 1781
8
Anna Morgan
[1.1.1.3.3.4.2.3]
b. 27 Feb 1734 d. 17 Mar 1761
8
Roswell Morgan
[1.1.1.3.3.4.2.4]
b. 17 Jul 1737 d. 26 Aug 1798
8
Dorothy Morgan
[1.1.1.3.3.4.2.5]
b. 28 Feb 1747 d. 1834
7
Mary Morgan
[1.1.1.3.3.4.3]
b. 21 Jun 1702
7
Isaac Morgan
[1.1.1.3.3.4.4]
b. 8 May 1706 d. 20 Jun 1725
7
Joseph Morgan
[1.1.1.3.3.4.5]
b. 15 Mar 1710
7
Olive Morgan
[1.1.1.3.3.4.6]
b. 23 Sep 1712
6
Hannah Morgan
[1.1.1.3.3.5]
b. 8 Jan 1674
6
Mercy Morgan
[1.1.1.3.3.6]
b. May 1675 d. 1754
6
Sarah Morgan
[1.1.1.3.3.7]
b. 13 Apr 1678 d. Aft 1714
5
Samuel Deming
[1.1.1.3.4]
b. 1646 d. 6 Apr 1709
5
Mary Deming
[1.1.1.3.5]
b. Abt 1648 d. 17 Dec 1714
5
David Deming
[1.1.1.3.6]
b. Abt 1650 d. May 1725
5
Elizabeth Deming
[1.1.1.3.7]
b. 1655
4
Henry Deming
[1.1.1.4]
b. 1617 d. 1618
4
Sarah Deming
[1.1.1.5]
b. Abt 1617 d. 9 Jul 1657
Emanuel Buck
b. Abt 1623 d. 13 Jun 1695
5
Ezekiel Buck
[1.1.1.5.1]
b. 15 Jan 1650 d. 3 Mar 1713
Rachel Andrus
b. 19 Apr 1654 d. 10 Dec 1712
6
Rachael Buck
[1.1.1.5.1.1]
b. 25 Jul 1675 d. 21 Jun 1708
6
Jonathan Buck
[1.1.1.5.1.2]
b. 23 Jul 1679 d. 1735
6
Stephen Buck
[1.1.1.5.1.3]
b. 2 Feb 1680 d. Abt 15 Jan 1747
6
Enoch Buck
[1.1.1.5.1.4]
b. 5 Apr 1683 d. 4 May 1770
Mary Beebe
b. 25 Sep 1699 d. 9 Jan 1774
7
Ebeneser Buck
[1.1.1.5.1.4.1]
b. 8 Jan 1718 d. 1825
7
Grace Buck
[1.1.1.5.1.4.2]
b. 22 Jan 1719 d. Oct 1785
7
Hannah Buck
[1.1.1.5.1.4.3]
b. 9 Jun 1720 d. 7 Jan 1798
7
William Buck
[1.1.1.5.1.4.4]
b. 23 Mar 1723 d. 13 Mar 1799
7
James Buck
[1.1.1.5.1.4.5]
b. 24 Mar 1726 d. 28 Jan 1793
7
Rachel Buck
[1.1.1.5.1.4.6]
b. 1 Apr 1730 d. 1800
Robert Hawkins
b. 15 Oct 1729 d. 19 Nov 1828
8
Abiel Hawkins
[1.1.1.5.1.4.6.1]
b. 27 May 1760 d. 1818
8
Resign Hawkins
[1.1.1.5.1.4.6.2]
b. 1761
8
Anna Betsy Hawkins
[1.1.1.5.1.4.6.3]
b. 7 Nov 1762 d. 23 Mar 1830
John K King
b. 25 Apr 1765 d. 2 Nov 1855
9
Eleazar King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1]
b. 11 Oct 1784 d. 14 May 1854
Nancy Fowler
b. 31 Mar 1788 d. 8 Nov 1845
10
Nancy Diana King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.1]
b. 1805 d. 1899
10
Abigail Morency King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.2]
b. 1807 d. 1860
10
John Morris King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.3]
b. 22 Sep 1809 d. 13 Nov 1855
Sarah Ann Jewell
b. 5 Mar 1814 d. 11 Nov 1873
11
Robert Edson King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.3.1]
b. 1 Nov 1834 d. 9 Nov 1921
11
Janie King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.3.2]
b. Abt 1837
11
Emma Melissa King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.3.3]
b. 18 Sep 1840 d. 10 Jan 1905
Isaiah Huntsman
b. 14 Sep 1826 d. 3 Jun 1878
12
Sarah Huntsman
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.3.3.1]
b. 11 Feb 1856 d. 21 Feb 1869
12
Mary Elizabeth Huntsman
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.3.3.2]
b. 4 Nov 1860 d. 9 Feb 1913
12
James Edson Huntsman
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.3.3.3]
b. 16 Mar 1863 d. 19 Aug 1926
12
Amanda Huntsman
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.3.3.4]
b. 2 Jul 1864 d. 20 Sep 1944
12
Jane Huntsman
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.3.3.5]
b. 18 Oct 1867 d. 20 Oct 1906
12
John Huntsman
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.3.3.6]
b. 16 Apr 1870 d. 23 Oct 1919
12
Emma Ada Huntsman
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.3.3.7]
b. 28 Aug 1875 d. 10 May 1949
11
Joseph Hyrum King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.3.4]
b. 2 Aug 1844 d. 22 Jul 1916
11
John Henry King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.3.5]
b. 2 Aug 1851 d. 19 Feb 1888
10
Eleazer King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.4]
b. 1 Dec 1811 d. 20 Mar 1897
Mary Caroline Fowler
b. 19 Nov 1818 d. 29 Mar 1880
11
Caroline Matilda King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.4.1]
b. 11 Dec 1836 d. 27 Mar 1916
11
Eveline Jenet King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.4.2]
b. 15 Apr 1838 d. 15 Apr 1838
11
Emily Jane King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.4.3]
b. 24 Mar 1840 d. 14 Sep 1880
11
Susan Nancy King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.4.4]
b. 23 Dec 1842 d. 23 Dec 1842
11
Mary Elizabeth King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.4.5]
b. 16 Oct 1847 d. 16 Oct 1847
11
Abigail Morana King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.4.6]
b. 16 Sep 1849 d. 24 Jul 1913
11
Samuel Eleazar King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.4.7]
b. 26 Jan 1852 d. 14 Nov 1900
Niels Ansine Sena Mickelsen
b. 26 Sep 1855 d. 17 Oct 1929
12
Samuel Warren King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.4.7.1]
b. 8 Oct 1873 d. 26 Oct 1886
12
Sena Olivia King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.4.7.2]
b. 21 Jul 1877 d. 15 Oct 1958
12
Christian Alonzo King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.4.7.3]
b. 11 Jul 1879 d. 29 Mar 1962 [
=>
]
12
Vernon King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.4.7.4]
b. 2 Feb 1889 d. 30 Apr 1900
11
Elsie Lavina King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.4.8]
b. 17 Mar 1854 d. 26 Mar 1925
11
George William King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.4.9]
b. 9 Nov 1856 d. 5 Jan 1917
11
Francis Enoch King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.4.10]
b. 21 Sep 1858 d. 5 Jan 1936
11
James Alonzo King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.4.11]
b. 12 Dec 1861 d. 12 Dec 1861
11
John Lorenzo King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.4.12]
b. 19 Jan 1864 d. 15 Apr 1874
10
Phoebe King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.5]
b. 1813
10
Lorenzo Don King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.6]
b. 13 Jun 1816 d. 20 Mar 1839
10
Alonzo F. King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.7]
b. 26 Aug 1819
10
Enoch Marvin King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.8]
b. 1 May 1821 d. 8 Apr 1895
Mary Bigg Ware
b. 11 May 1816 d. 8 Dec 1911
11
Enoch George King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.8.1]
b. 14 Jan 1843 d. 3 Oct 1846
11
Hyrum Smith King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.8.2]
b. 7 Oct 1844 d. 17 Oct 1937
11
Alonzo Marvin King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.8.3]
b. 3 Jul 1847 d. 15 May 1938
Frances Ellen Robins
b. 5 Sep 1849 d. 19 Aug 1936
12
Alonzo King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.8.3.1]
b. 16 Nov 1868 d. 21 Feb 1869
12
James Fredrick King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.8.3.2]
b. 6 Jun 1870 d. 19 Nov 1949 [
=>
]
12
Elizabeth Emiline King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.8.3.3]
b. 5 May 1872 d. 22 Apr 1901 [
=>
]
12
Mary Maria King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.8.3.4]
b. 15 Sep 1874 d. 30 May 1951 [
=>
]
12
Capitola Kate King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.8.3.5]
b. 30 Mar 1876 d. 30 Mar 1952 [
=>
]
12
Garnetta King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.8.3.6]
b. 15 Mar 1878 d. 27 Apr 1878
12
Eliza Ellen King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.8.3.7]
b. 5 May 1879 d. 23 Feb 1963 [
=>
]
12
Lillie May King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.8.3.8]
b. 5 May 1881 d. 20 May 1881
12
Marvin Edwin King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.8.3.9]
b. 18 Jan 1883 d. 2 Aug 1958 [
=>
]
12
Ruth King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.8.3.10]
b. 2 Jun 1885 d. 3 Jun 1888
12
Vilate Ann King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.8.3.11]
b. 15 Mar 1887 d. 2 Sep 1974
12
Luella King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.8.3.12]
b. 4 Dec 1889 d. 15 Mar 1977 [
=>
]
11
Joseph Smith King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.8.4]
b. 24 Jan 1849 d. 11 Jun 1927
11
James Eleazer King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.8.5]
b. 10 Jun 1850 d. 17 Nov 1909
11
John Lorenzo King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.8.6]
b. 22 May 1852 d. 1 Jul 1936
11
Nancy Emeline Young King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.8.7]
b. 7 Sep 1854 d. 23 Jul 1938
11
Mary Sariah King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.8.8]
b. 4 Oct 1855 d. 29 Jul 1945
Peter Barton
b. 22 Mar 1850 d. 12 Dec 1924
12
Hulda Elizabeth Barton
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.8.8.1]
b. 25 Sep 1876 d. 15 Jul 1954
12
Sarah Katherine Barton
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.8.8.2]
b. 30 Apr 1878 d. 28 Mar 1936
12
Edmond Joseph Barton
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.8.8.3]
b. 14 Jun 1880 d. 14 Jun 1880
12
Mary Ann Barton
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.8.8.4]
b. 8 Aug 1881 d. 21 Oct 1936 [
=>
]
12
Naomi Ruth Barton
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.8.8.5]
b. 22 Nov 1883 d. 16 Jan 1973
12
Peter Lorenzo Barton
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.8.8.6]
b. 4 Dec 1885 d. 7 Sep 1931
12
Pearl Barton
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.8.8.7]
b. 28 Dec 1887 d. 28 Dec 1887
12
Alice Jeannette ( Janetta) Barton
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.8.8.8]
b. 7 Feb 1889 d. 15 Feb 1920
12
Luella Barton
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.8.8.9]
b. 15 Apr 1891 d. 27 Nov 1957
12
John Hyrum Barton
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.8.8.10]
b. 16 Jun 1893 d. 7 Dec 1918
12
Emma Emaline Barton
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.8.8.11]
b. 31 Dec 1895 d. 17 Dec 1984
12
Enoch Henry Barton
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.8.8.12]
b. 22 Apr 1899 d. 5 Dec 1918
11
Sarah Elizabeth King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.8.9]
b. 18 Aug 1858 d. 21 May 1928
11
Daughter King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.8.10]
b. 1861 d. 1867
10
Huldah King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.9]
b. 22 Jun 1822 d. 17 Mar 1897
10
Mary King
[1.1.1.5.1.4.6.3.1.10]
b. 1824
9
Abigail Nabby King
[1.1.1.5.1.4.6.3.2]
b. 30 Mar 1787 d. 1860
9
Joel Baldwin King
[1.1.1.5.1.4.6.3.3]
b. 9 Aug 1789
9
John King
[1.1.1.5.1.4.6.3.4]
b. 30 Jan 1790 d. Bef 1 Jan 1850
9
James King
[1.1.1.5.1.4.6.3.5]
b. 5 Feb 1793 d. 31 Dec 1876
9
Sarah King
[1.1.1.5.1.4.6.3.6]
b. 7 Aug 1794 d. 30 Sep 1851
9
Rhoda King
[1.1.1.5.1.4.6.3.7]
b. 13 Feb 1796 d. 8 Apr 1878
9
Lydia King
[1.1.1.5.1.4.6.3.8]
b. 14 Sep 1800 d. 11 Jun 1862
8
Rebecca Hawkins
[1.1.1.5.1.4.6.4]
b. 1763 d. 26 Jun 1817
8
Elijah Hawkins
[1.1.1.5.1.4.6.5]
b. 1767 d. Abt 1828
8
Enoch Hawkins
[1.1.1.5.1.4.6.6]
b. 10 Jul 1768 d. 1826
8
Mary Hawkins
[1.1.1.5.1.4.6.7]
b. Abt 1771 d. 12 Apr 1846
8
Ebenezer Hawkins
[1.1.1.5.1.4.6.8]
b. 22 Apr 1772 d. 23 Sep 1828
7
Dorothy Buck
[1.1.1.5.1.4.7]
b. 30 Oct 1734 d. 1734
7
Daniel Buck
[1.1.1.5.1.4.8]
b. 27 Feb 1737 d. 13 Apr 1814
7
Jerusha Buck
[1.1.1.5.1.4.9]
b. 25 Aug 1739 d. 23 Sep 1778
6
Ebenezer Buck
[1.1.1.5.1.5]
b. Abt 1685 d. 10 Nov 1712
6
Mary Buck
[1.1.1.5.1.6]
b. 31 Jan 1687 d. 1727
6
Hannah Buck
[1.1.1.5.1.7]
b. Jan 1688 d. 12 Jun 1749
6
Comfort Buck
[1.1.1.5.1.8]
b. Abt 1690 d. 1755
6
Ezekiel Buck
[1.1.1.5.1.9]
b. 8 Jan 1676 d. 3 Mar 1713
5
Jonathan Buck
[1.1.1.5.2]
b. 8 Apr 1655 d. 1735
4
Samuel Deming
[1.1.1.6]
b. Abt 1620 d. 21 Nov 1705
4
Thomas Deming
[1.1.1.7]
b. Abt 1620 d. Mar 1683
3
Jonathan Gilbert
[1.1.2]
b. 29 Jul 1581
3
Lydia Gilbert
[1.1.3]
b. 16 Dec 1587 d. 12 May 1637
2
Thomasine Belgrave
[1.2]
b. 11 Aug 1560 d. 13 Jun 1653
Edward Frost
b. 13 Mar 1561 d. 3 Aug 1616
3
Anne Frost
[1.2.1]
b. 3 Dec 1592 d. 26 Dec 1642
3
Thomasine Frost
[1.2.2]
b. 1593 d. 13 Jun 1654
Edmund Rice
b. 28 Aug 1593 d. 12 Jul 1672
4
Henry Rice
[1.2.2.1]
b. 13 Feb 1621 d. 10 Feb 1711
Elizabeth Moore
b. 1624 d. 23 Aug 1705
5
Mary Rice
[1.2.2.1.1]
b. 19 Sep 1646 d. 3 May 1695
Thomas Brigham
b. 9 Mar 1641 d. 25 Nov 1717
6
Nathan Brigham
[1.2.2.1.1.1]
b. 17 Jun 1671 d. 16 Feb 1746
6
Jonathan Brigham
[1.2.2.1.1.2]
b. 22 Feb 1674 d. 4 Jan 1768
6
David Brigham
[1.2.2.1.1.3]
b. 12 Apr 1678 d. 26 Jun 1750
6
Gershom Brigham
[1.2.2.1.1.4]
b. 23 Feb 1680 d. 3 Jan 1749
6
Elnathan Brigham
[1.2.2.1.1.5]
b. 7 Mar 1683 d. 10 Apr 1758
6
Priscilla Brigham
[1.2.2.1.1.6]
b. Feb 1685 d. 10 Apr 1685
6
Mary Brigham
[1.2.2.1.1.7]
b. 26 Oct 1687 d. 30 Jun 1710
5
Elizabeth Joanna Rice
[1.2.2.1.2]
b. 4 Aug 1648 d. 25 Sep 1739
5
Hannah Rice
[1.2.2.1.3]
b. 1653 d. 11 Aug 1707
5
Jonathon Rice
[1.2.2.1.4]
b. 3 Jul 1654 d. 12 Apr 1725
5
Abigail Rice
[1.2.2.1.5]
b. 17 Jun 1657 d. 9 Dec 1735
5
David Rice
[1.2.2.1.6]
b. 27 Dec 1659 d. 16 Oct 1723
5
Thomasine Rice
[1.2.2.1.7]
b. 2 Feb 1661 d. 15 Apr 1748
5
Rachel Rice
[1.2.2.1.8]
b. 10 May 1664 d. 10 Mar 1730
5
Lydia Rice
[1.2.2.1.9]
b. 4 Jun 1668 d. 6 Apr 1756
5
Mercy Rice
[1.2.2.1.10]
b. 1 Jan 1670 d. 1727
4
Edward Rice
[1.2.2.2]
b. 20 Oct 1622 d. 16 Aug 1712
Agnes Bent
b. 12 Dec 1631 d. 4 Jun 1713
5
Lydia Rice
[1.2.2.2.1]
b. 30 Jul 1648 d. 30 Jul 1648
5
Lydia Rice
[1.2.2.2.2]
b. 10 Dec 1649 d. 24 Sep 1723
5
John Rice
[1.2.2.2.3]
b. 20 Dec 1651 d. 6 Sep 1719
Tabitha Stone
b. 29 May 1655 d. 17 Sep 1719
6
John Rice
[1.2.2.2.3.1]
b. 29 Sep 1675 d. 28 Jul 1733
6
Anna Rice
[1.2.2.2.3.2]
b. 29 Aug 1678 d. 5 Nov 1753
6
Deliverance Rice
[1.2.2.2.3.3]
b. 14 Aug 1681 d. 1723
6
Tabitha Rice
[1.2.2.2.3.4]
b. 23 Nov 1683 d. 26 Mar 1718
Thomas Cutler
b. 19 Jan 1677 d. 26 Mar 1718
7
Abner Cutler
[1.2.2.2.3.4.1]
b. 16 Jul 1701 d. 23 Jan 1751
Anna Haynes
b. 23 Dec 1713 d. Abt 1800
8
Thomas Cutler
[1.2.2.2.3.4.1.1]
b. 17 Sep 1736 d. 7 Oct 1835
Rebecca Hyde
b. 2 Mar 1752 d. 7 May 1835
9
Lydia Cutler
[1.2.2.2.3.4.1.1.1]
b. 23 Oct 1772 d. 3 Aug 1830
9
Thomas Cutler
[1.2.2.2.3.4.1.1.2]
b. 24 May 1774 d. 11 Jul 1848
9
Naham Cutler
[1.2.2.2.3.4.1.1.3]
b. 14 May 1776 d. 10 Sep 1840
Martha Robbins
b. 1781 d. 1879
10
Luke H Cutler
[1.2.2.2.3.4.1.1.3.1]
b. 21 Aug 1805 d. 28 May 1887
Axenia Barber
b. Abt 1808
11
Martha B Cutler
[1.2.2.2.3.4.1.1.3.1.1]
b. 6 Nov 1830 d. 22 Aug 1855
11
Axenia Cutler
[1.2.2.2.3.4.1.1.3.1.2]
b. 7 Dec 1832 d. Abt 1860
11
Martin B Cutler
[1.2.2.2.3.4.1.1.3.1.3]
b. 2 Dec 1834 d. 29 Mar 1885
11
Elizabeth R Cutler
[1.2.2.2.3.4.1.1.3.1.4]
b. 14 Nov 1836
11
Charles J Cutler
[1.2.2.2.3.4.1.1.3.1.5]
b. 10 Apr 1842
11
Caroline Cutler
[1.2.2.2.3.4.1.1.3.1.6]
b. 17 Dec 1844 d. 28 Feb 1846
11
Frank Luke Cutler
[1.2.2.2.3.4.1.1.3.1.7]
b. 3 Dec 1849 d. 11 Aug 1935
Sarah Elizabeth "Lizzy" Shaffer
b. 19 Jul 1851 d. 8 Aug 1887
12
Burt Melvin Cutler
[1.2.2.2.3.4.1.1.3.1.7.1]
b. 28 Jul 1874 d. 1 Jul 1928
12
Myra Edith Cutler
[1.2.2.2.3.4.1.1.3.1.7.2]
b. 13 Mar 1877 d. 21 Jul 1955 [
=>
]
10
George H Cutler
[1.2.2.2.3.4.1.1.3.2]
b. 29 Oct 1809 d. 26 Jul 1892
10
Helen R Cutler
[1.2.2.2.3.4.1.1.3.3]
b. 5 Apr 1812 d. 20 Mar 1894
9
Fanny Cutler
[1.2.2.2.3.4.1.1.4]
b. 4 Oct 1779
9
Pliney Cutler
[1.2.2.2.3.4.1.1.5]
b. 4 Oct 1779 d. 5 Mar 1845
9
Hannah Cutler
[1.2.2.2.3.4.1.1.6]
b. 27 Jan 1782 d. 29 Dec 1864
9
Joshua Cutler
[1.2.2.2.3.4.1.1.7]
b. 1 Nov 1783 d. 26 Sep 1839
9
Rebecca Cutler
[1.2.2.2.3.4.1.1.8]
b. 1 Nov 1783 d. 15 Sep 1838
9
Johnathan Cutler
[1.2.2.2.3.4.1.1.9]
b. 8 Dec 1786 d. 20 Jun 1849
9
Anna Cutler
[1.2.2.2.3.4.1.1.10]
b. 8 Sep 1788
9
Zenas Cutler
[1.2.2.2.3.4.1.1.11]
b. 3 Apr 1791 d. 5 Dec 1794
9
Jane Cutler
[1.2.2.2.3.4.1.1.12]
b. 5 Sep 1793 d. 9 Aug 1795
8
Joel Cutler
[1.2.2.2.3.4.1.2]
b. 19 Mar 1737 d. 5 Jun 1821
8
Ann Cutler
[1.2.2.2.3.4.1.3]
b. 1 Sep 1740 d. 31 May 1784
8
James Cutler
[1.2.2.2.3.4.1.4]
b. 18 Feb 1742/1743 d. 1821
8
Abner Cutler
[1.2.2.2.3.4.1.5]
b. 19 Apr 1745
8
Eunice Cutler
[1.2.2.2.3.4.1.6]
b. 4 Apr 1747
8
Silas Cutler
[1.2.2.2.3.4.1.7]
b. 23 Apr 1749 d. 1821
8
Abigail Cutler
[1.2.2.2.3.4.1.8]
b. 3 May 1751
7
Tabitha Cutler
[1.2.2.2.3.4.2]
b. Abt 1703
7
James Cutler
[1.2.2.2.3.4.3]
b. 14 Jan 1704 d. 13 Dec 1740
7
Thankful Cutler
[1.2.2.2.3.4.4]
b. 17 Feb 1710 d. 13 Dec 1798
7
Lois Cutler
[1.2.2.2.3.4.5]
b. 1 Dec 1711
7
Eunice Cutler
[1.2.2.2.3.4.6]
b. 28 Aug 1716
7
Thomas Cutler
[1.2.2.2.3.4.7]
b. 8 Feb 1718
6
Prudence Rice
[1.2.2.2.3.5]
b. 26 Jul 1685
6
Abigail Rice
[1.2.2.2.3.6]
b. 27 Nov 1687 d. 10 Jun 1754
6
Edward Rice
[1.2.2.2.3.7]
b. 23 Dec 1689 d. 27 Sep 1756
6
Dinah Rice
[1.2.2.2.3.8]
b. 10 Feb 1691 d. 5 Jun 1716/1717
6
Moses Rice
[1.2.2.2.3.9]
b. 27 Oct 1694 d. 11 Jun 1755
6
Tamar Rice
[1.2.2.2.3.10]
b. 29 Sep 1697 d. 6 Mar 1765
6
Aaron Rice
[1.2.2.2.3.11]
b. 13 Aug 1700 d. 1755
5
Daniel Rice
[1.2.2.2.4]
b. 8 Nov 1655 d. 14 Jul 1737
5
Jacob Rice
[1.2.2.2.5]
b. 1 Mar 1660 d. 30 Oct 1746
5
Anna Rice
[1.2.2.2.6]
b. 19 Nov 1661 d. 2 May 1731
5
Dorcas Rice
[1.2.2.2.7]
b. 29 Jan 1664 d. 24 Mar 1753
5
Benjamin Rice
[1.2.2.2.8]
b. 22 Dec 1666 d. 23 Feb 1749
5
Abigail Rice
[1.2.2.2.9]
b. 9 May 1671
4
Thomas Rice
[1.2.2.3]
b. 26 Jan 1626 d. 16 Nov 1681
Mary King
b. 22 Feb 1629 d. 22 Mar 1715
5
Grace Rice
[1.2.2.3.1]
b. 3 Jan 1653 d. 3 Jan 1653
5
Thomas Rice, Jr
[1.2.2.3.2]
b. 30 Jun 1654 bur. 26 Dec 1748
5
Peter Rice
[1.2.2.3.3]
b. 24 Oct 1658 d. 28 Nov 1753
5
Nathaniel Rice
[1.2.2.3.4]
b. 3 Jan 1660 d. 13 Nov 1726
5
Ephraim Rice
[1.2.2.3.5]
b. 15 Apr 1665 d. 25 Oct 1732
Hannah Livermore
b. 27 Sep 1670 d. 25 May 1724
6
Ephraim Rice, Jr
[1.2.2.3.5.1]
b. 26 Sep 1693 d. 1742
Sarah Whitney
b. 20 Jun 1697 d. 27 Jan 1776
7
Amos Rice
[1.2.2.3.5.1.1]
b. 10 Sep 1727 d. 31 May 1807
7
Abigail Lucinda Rice
[1.2.2.3.5.1.2]
b. 28 Mar 1732 d. 20 Jun 1793
7
Sarah Rice
[1.2.2.3.5.1.3]
b. Abt 1737
7
Bathsheba Rice
[1.2.2.3.5.1.4]
b. 5 Jun 1742 d. 10 May 1792
Jonathan Sawtell Alexander
b. 1749 d. 7 Mar 1838
8
Robert Alexander
[1.2.2.3.5.1.4.1]
b. 1778 d. 1829
8
Austin Alexander
[1.2.2.3.5.1.4.2]
b. Abt 1779
8
Reuben Alexander
[1.2.2.3.5.1.4.3]
b. 1780
8
Joseph Alexander
[1.2.2.3.5.1.4.4]
b. 14 Mar 1782 d. 11 Apr 1843
8
Aaron Alexander
[1.2.2.3.5.1.4.5]
b. 15 Jul 1787 d. 15 Sep 1820
Betsey Jones
b. 30 Mar 1791 d. 26 Apr 1861
9
Eli Jones Alexander
[1.2.2.3.5.1.4.5.1]
b. Dec 1814 d. 2 Jul 1863
9
Nancy Naomi Alexander
[1.2.2.3.5.1.4.5.2]
b. 14 May 1816 d. 11 Mar 1902
Moses Tracy
b. 11 Apr 1810 d. 25 Aug 1858
10
Eli Alexander Tracy
[1.2.2.3.5.1.4.5.2.1]
b. 25 Nov 1833 d. 1 Jan 1917
10
Lachoneus Moroni Tracy
[1.2.2.3.5.1.4.5.2.2]
b. 29 Oct 1835 d. 3 Aug 1846
10
Moses Mosiah Tracy
[1.2.2.3.5.1.4.5.2.3]
b. 7 Sep 1838
10
William Frances Tracy
[1.2.2.3.5.1.4.5.2.4]
b. 22 Jun 1840 d. 29 Mar 1842
10
Theodore Franklin Tracy
[1.2.2.3.5.1.4.5.2.5]
b. 18 Jun 1843 d. 18 Aug 1845
10
Austin Walter Tracy
[1.2.2.3.5.1.4.5.2.6]
b. 15 Mar 1845 d. 20 Jan 1924
10
Helon Henry Alexander Tracy
[1.2.2.3.5.1.4.5.2.7]
b. 25 Feb 1849 d. 25 Apr 1893
Emma Maria Burdett
b. 22 Sep 1851 d. 2 Jun 1933
11
Annie Marie Fannie Tracy
[1.2.2.3.5.1.4.5.2.7.1]
b. 25 Feb 1868 d. 12 Oct 1959
11
Emma Naomi Tracy
[1.2.2.3.5.1.4.5.2.7.2]
b. 6 May 1870 d. 15 Mar 1948
11
Helon Henry Tracy
[1.2.2.3.5.1.4.5.2.7.3]
b. 5 Apr 1872 d. 27 Sep 1948
11
Mary Eliza Tracy
[1.2.2.3.5.1.4.5.2.7.4]
b. 3 Mar 1874 d. 30 Sep 1949
Byron Harvey Allred
b. 29 May 1847 d. 6 Aug 1912
12
Byron Harvey Allred, Jr
[1.2.2.3.5.1.4.5.2.7.4.1]
b. 31 Mar 1870 d. 18 Jan 1937
12
Myra Irene Allred
[1.2.2.3.5.1.4.5.2.7.4.2]
b. 10 Apr 1872 d. 9 Sep 1912
12
Henry Garcia Allred
[1.2.2.3.5.1.4.5.2.7.4.3]
b. 8 Feb 1895 d. 19 Nov 1954
12
Lorain Tracy Allred
[1.2.2.3.5.1.4.5.2.7.4.4]
b. 26 Feb 1897 d. 26 Nov 1897
12
Lorain Tracy Allred
[1.2.2.3.5.1.4.5.2.7.4.5]
b. 26 Feb 1897 d. 26 Oct 1897
12
Lavon Tracy Allred
[1.2.2.3.5.1.4.5.2.7.4.6]
b. 7 Oct 1901 d. 29 Aug 1995
12
Mary Viola Allred
[1.2.2.3.5.1.4.5.2.7.4.7]
b. 26 Apr 1904 d. 15 Jan 2000 [
=>
]
11
Richard Israel Tracy
[1.2.2.3.5.1.4.5.2.7.5]
b. 17 Sep 1876 d. 3 Jul 1943
11
Adam Herbert Tracy
[1.2.2.3.5.1.4.5.2.7.6]
b. 17 Oct 1878 d. 12 Oct 1948
11
Ruth Miriam Tracy
[1.2.2.3.5.1.4.5.2.7.7]
b. 15 Sep 1880 d. 4 May 1949
11
Cyrus Albert Tracy
[1.2.2.3.5.1.4.5.2.7.8]
b. 28 Apr 1883 d. 14 Dec 1883
11
Ellen Imogene Tracy
[1.2.2.3.5.1.4.5.2.7.9]
b. 25 Nov 1884 d. 20 Aug 1885
11
Sarah Almyra Tracy
[1.2.2.3.5.1.4.5.2.7.10]
b. 25 Nov 1884 d. 12 May 1936
11
Florence Almina Tracy
[1.2.2.3.5.1.4.5.2.7.11]
b. 7 Nov 1886 d. 23 May 1966
11
Mormon Harold Tracy
[1.2.2.3.5.1.4.5.2.7.12]
b. 4 Jun 1888 d. 25 May 1972
11
Lydia Frances Tracy
[1.2.2.3.5.1.4.5.2.7.13]
b. 15 Jun 1890 d. 8 Jun 1970
11
Blanche Marion Tracy
[1.2.2.3.5.1.4.5.2.7.14]
b. 9 Jul 1892 d. 20 Jul 1966
10
David Seymour Tracy
[1.2.2.3.5.1.4.5.2.8]
b. 2 May 1852 d. 7 Oct 1946
10
Charles Albert Tracy
[1.2.2.3.5.1.4.5.2.9]
b. 19 Jun 1854 d. 19 Jun 1922
10
Mary Ellen Naomi Tracy
[1.2.2.3.5.1.4.5.2.10]
b. 18 Sep 1857 d. 3 Dec 1937
9
Almina S Alexander
[1.2.2.3.5.1.4.5.3]
b. Abt 1818 d. 9 Jun 1897
9
Albert Gale Alexander
[1.2.2.3.5.1.4.5.4]
b. 2 Jun 1818 d. 16 Aug 1911
8
Daughter Alexander
[1.2.2.3.5.1.4.6]
b. Abt 1788
8
Asa Alexander
[1.2.2.3.5.1.4.7]
b. 1790 d. 1863
7
Zervilla Rice
[1.2.2.3.5.1.5]
b. Abt 1746 d. 30 Oct 1812
6
Josiah Rice
[1.2.2.3.5.2]
b. 6 Sep 1696 d. 28 Mar 1730
6
Grace Rice
[1.2.2.3.5.3]
b. 7 Jun 1699 d. 29 Oct 1704
6
Thomas Rice
[1.2.2.3.5.4]
b. 21 Mar 1702 d. Abt 17 Dec 1785
6
Gershom Rice
[1.2.2.3.5.5]
b. 17 Jun 1703 d. 1752
6
John Rice
[1.2.2.3.5.6]
b. 23 Apr 1704 d. 1771
6
Isaac Rice
[1.2.2.3.5.7]
b. Jun 1710 d. 20 Oct 1793
5
Gershom Rice
[1.2.2.3.6]
b. 9 May 1667 d. 19 Dec 1768
5
James Rice
[1.2.2.3.7]
b. 31 Mar 1669 d. 14 Oct 1730
5
Frances Rice
[1.2.2.3.8]
b. 3 Feb 1670 d. 12 Aug 1721
5
Jonas Rice
[1.2.2.3.9]
b. 6 Mar 1672 d. 20 Sep 1753
5
Grace Rice
[1.2.2.3.10]
b. 15 Jan 1675 d. 3 Jan 1768
5
Elisha Rice
[1.2.2.3.11]
b. 4 Dec 1679 d. 22 Sep 1761
4
Lydia Rice
[1.2.2.4]
c. 9 Mar 1627 d. 5 Apr 1675
4
Samuel Rice
[1.2.2.5]
b. 12 Nov 1634 d. 25 Feb 1685
4
Edward Rice
[1.2.2.6]
b. 1636 d. 1660
Mary Claiborne
b. 1632 d. 2 Sep 1710
5
Claiborne Rice
[1.2.2.6.1]
b. 1649 bur. Jan 1740
5
Edward Rice
[1.2.2.6.2]
b. 1652
5
Thomas Rice
[1.2.2.6.3]
b. 1656 d. 1711
Marcy Ann Hewes
b. 1664 d. 1722
6
William Rice
[1.2.2.6.3.1]
b. 4 Apr 1686 d. 6 Dec 1734
6
Thomas Rice, Jr
[1.2.2.6.3.2]
b. 24 Jun 1688 d. 28 Jan 1745
Mary Fisher
b. 1688 d. 1728
7
Thomas Rice
[1.2.2.6.3.2.1]
b. Abt 1708 d. 13 Apr 1800
7
Elizabeth Rice
[1.2.2.6.3.2.2]
b. Abt 1710 d. 1774
Richard Bennett
c. 1 May 1709 d. 1786
8
Rice Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1]
b. 1726 d. 24 Aug 1772
Sarah Hampton
b. 1733 d. 19 Sep 1796
9
Mary Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.1]
b. Abt 1753
9
William Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2]
b. Abt 1755 d. May 1823
Catherine Bernard
b. 1758 d. Feb 1831
10
Mary Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.1]
b. 6 Mar 1776 d. 16 Aug 1847
10
Elisha Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.2]
b. Abt 1777 d. Bef 14 Oct 1839
10
Elizabeth Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.3]
b. 23 Aug 1782
10
Richard Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.4]
b. 30 Mar 1785 d. 30 Aug 1835
+
Mary Bell
b. 5 Dec 1786 d. 12 Apr 1856
10
Martha Jane Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.5]
b. Abt 1786 d. 20 Oct 1871
10
Lucy Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.6]
b. Abt 1788 d. Aft 1850
10
William Junior Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7]
b. 22 Jul 1790 d. 1 Oct 1846
Elizabeth Bell
b. 4 Nov 1792 d. 5 Nov 1864
11
Austin Bell Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.1]
b. 11 Dec 1814 d. 8 Jul 1896
Angelina Storm
b. 8 Nov 1818 d. 25 Sep 1854
12
John J Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.1.1]
b. Abt 1839 [
=>
]
12
Eli Preston Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.1.2]
b. Abt 1840 [
=>
]
12
Sarah Ann Elizabeth Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.1.3]
b. 14 Aug 1842 d. 30 Apr 1934 [
=>
]
12
Adolphus J Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.1.4]
b. 1842
12
Samuel Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.1.5]
b. Abt 1847 d. Abt 1919 [
=>
]
12
William Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.1.6]
b. 1848 d. Bef 1896 [
=>
]
12
David L Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.1.7]
b. 14 Jun 1851 d. 13 Dec 1932
12
Vina J Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.1.8]
b. 1854 d. 6 Oct 1854
Lucretia Jane Aldridge
b. 8 Feb 1831 d. 5 Mar 1910
12
Mary Angeline Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.1.9]
b. 1857 [
=>
]
12
Thomas F Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.1.10]
b. 1860 d. Bef 1896
12
Eliza Jane Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.1.11]
b. 1862 [
=>
]
12
Hiram Washington Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.1.12]
b. 1866 d. 21 Jun 1910 [
=>
]
12
Patrick Henry Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.1.13]
b. 1869 d. 1946 [
=>
]
11
Thomas McGuire Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.2]
b. 24 Feb 1816 d. 24 Feb 1894
Sarah Bennett
b. 1815
12
Elizabeth E Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.2.1]
b. 22 Jan 1837 d. 2 May 1911 [
=>
]
12
Thomas J Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.2.2]
b. Nov 1839
12
Margaret F Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.2.3]
b. 1842
12
James Washington Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.2.4]
b. 25 Jul 1857 d. 25 Apr 1920 [
=>
]
Margaret Lavina Wilson
b. 22 Feb 1815 d. 30 Oct 1907
12
William Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.2.5]
b. 25 May 1849 d. 23 Aug 1904 [
=>
]
11
Sarah Ann Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.3]
b. 8 Oct 1817
11
Eliza Catherine Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.4]
b. 19 Jan 1819
Samuel Downes
b. 1830 d. 16 Jan 1894
12
Samuel Downes
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.4.1]
b. 1854
12
Elizabeth Downes
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.4.2]
b. 1856
12
Arthur Downes
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.4.3]
b. 1857 [
=>
]
12
Frederick Downes
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.4.4]
b. 1860
11
Mary Jane Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.5]
b. 1 Jan 1821 d. 25 Jun 1852
Jesse Temple McCauslin
b. 24 Feb 1817 d. 6 Mar 1884
12
William Y McCauslin
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.5.1]
b. Abt 1850 d. 8 Apr 1865
12
Sally McCauslin
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.5.2]
b. Abt 1848 d. 26 Jun 1852
11
Hiram Bell Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.6]
b. 1 Mar 1823 d. 17 Aug 1912
Martha Smith
b. 9 Jun 1817 d. 12 Oct 1902
12
Henry Bell Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.6.1]
b. Jun 1846 d. Jun 1846
12
Hyrum William Asahel Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.6.2]
b. 22 Nov 1848 d. 9 Jan 1849
12
Martha Eliza Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.6.3]
b. 24 Jan 1849 d. 6 May 1924 [
=>
]
12
Ezra Melanthorn Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.6.4]
b. 20 Oct 1851 d. 25 Aug 1852
12
Emily Jane Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.6.5]
b. 17 Jan 1854 d. 4 May 1903 [
=>
]
12
Elizabeth Emma Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.6.6]
b. 2 Jul 1856 d. 26 Feb 1940 [
=>
]
12
Elias Austin Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.6.7]
b. 26 Jan 1858 d. 1 May 1861
Ellen Greenhalgh
b. 27 Jul 1851 d. 4 May 1890
12
Jesse Johnson Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.6.8]
b. 25 Jul 1869 d. 22 Sep 1949 [
=>
]
12
George Alfred Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.6.9]
b. 27 Apr 1871 d. 27 Apr 1943 [
=>
]
12
Sarah Ellen Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.6.10]
b. 9 Feb 1873 d. 13 Jun 1961 [
=>
]
12
Esther Pricilla Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.6.11]
b. 20 Sep 1874 d. 1 Apr 1966
12
Mary Alice Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.6.12]
b. 4 Nov 1876 d. 17 Jun 1972 [
=>
]
12
Lucy Belle Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.6.13]
b. 4 Jul 1878 d. 6 Feb 1968 [
=>
]
12
Minnie Margaret Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.6.14]
b. 15 Apr 1880 d. 29 Jul 1961 [
=>
]
12
Clara Marinda Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.6.15]
b. 3 Feb 1883 d. 27 Sep 1966
12
Edith Ann Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.6.16]
b. 3 Jan 1885 d. 9 Jul 1947 [
=>
]
12
Albert Eli Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.6.17]
b. 20 Mar 1887 d. 11 Aug 1953 [
=>
]
12
Peter Preston Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.6.18]
b. 4 Oct 1888 d. 1 Dec 1967 [
=>
]
11
William M Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.7]
b. 4 Nov 1824
11
Martha Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.8]
b. 4 Jun 1825 d. 25 Dec 1867
William James Calkins
b. 17 Oct 1822 d. 10 Jun 1892
12
Eliza Ann Calkins
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.8.1]
b. 28 Jan 1854 d. 26 May 1930 [
=>
]
12
Martha Emeline Calkins
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.8.2]
b. Abt 1858 d. 1860
12
William Cyril Calkins, Jr
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.8.3]
b. 10 Aug 1864 d. 10 Jul 1929 [
=>
]
12
Alfred Arden Calkins
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.8.4]
b. 23 Dec 1867 d. 26 Dec 1867
11
George Alfred Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.9]
b. 4 May 1828 d. 18 Apr 1906
Lucy Ann Susan Saxey
b. 13 Jan 1842 d. 15 Jan 1892
12
Hannah Louisa Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.9.1]
b. 8 May 1860 d. 27 Aug 1921 [
=>
]
12
John Alfred Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.9.2]
b. 1 Jul 1864 d. 24 Jul 1948 [
=>
]
12
Mary Ellen Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.9.3]
b. 23 Sep 1866 d. 3 Feb 1928 [
=>
]
12
Elizabeth Lucy Ann Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.9.4]
b. 24 Aug 1861 d. 2 Nov 1893 [
=>
]
12
Willey Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.9.5]
b. 1869
12
George W Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.9.6]
b. 10 Dec 1869 d. 4 Jan 1936
12
Rosalle Elvira Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.9.7]
b. 15 Oct 1852 d. 20 Jul 1939 [
=>
]
12
William Daniel Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.9.8]
b. 10 Dec 1884 d. 18 Aug 1958 [
=>
]
12
Albert Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.9.9]
b. May 1885 d. 7 Jul 1923
11
John Bell Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.10]
b. 16 May 1830 d. 2 Feb 1902
Mary Senior
b. 2 Mar 1839 d. 20 May 1891
12
Mary Catherine Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.10.1]
b. 24 Oct 1863 d. 1864
12
John William Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.10.2]
b. 1864 d. 1864
12
Austin Robert Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.10.3]
b. 14 Jan 1866 d. 22 Sep 1942 [
=>
]
12
Ellen Elizabeth Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.10.4]
b. 1867 d. 1867
12
William Hyrum Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.10.5]
b. 27 Oct 1869 d. 24 Apr 1947 [
=>
]
12
George Edward Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.10.6]
b. 19 Mar 1871 d. 3 Jan 1874
12
John Bell Bennett, Jr
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.10.7]
b. 11 Oct 1872 d. 28 Feb 1946 [
=>
]
12
David Alfred Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.10.8]
b. 8 Aug 1874 d. 11 Oct 1945 [
=>
]
12
Sidney Redfern Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.10.9]
b. 18 Nov 1876 d. 27 Sep 1877
12
Samuel Senior Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.10.10]
b. 18 Nov 1876 d. 20 Jan 1951 [
=>
]
12
Joseph McGuire Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.10.11]
b. 13 Sep 1878 d. 4 Jan 1944 [
=>
]
12
Franklin Tennyson Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.10.12]
b. 21 Aug 1881 d. 25 Oct 1957 [
=>
]
11
Nancy Ellen Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.11]
b. 4 Jul 1833 d. 20 Mar 1909
Jesse Temple McCauslin
b. 24 Feb 1817 d. 6 Mar 1884
12
Mary Jane McCauslin
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.11.1]
b. 16 Apr 1854 d. 14 Jul 1939 [
=>
]
12
Sarah Ann McCauslin
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.11.2]
b. 29 Aug 1855 d. 30 Jan 1932 [
=>
]
12
Lydia Ellen McCauslin
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.11.3]
b. 1 May 1856 d. 3 Sep 1858
12
Caroline McCauslin
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.11.4]
b. 14 Nov 1858 d. 23 Sep 1930 [
=>
]
12
Jesse B McCauslin
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.11.5]
b. 13 Sep 1860 d. 16 Dec 1909 [
=>
]
12
George A McCauslin
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.11.6]
b. 6 Dec 1862 d. 12 Apr 1865
12
Alonzo McCauslin
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.11.7]
b. 1 May 1865 d. 22 May 1865
12
Elizabeth Mahala McCauslin
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.7.11.8]
b. 6 Jan 1867 d. 27 Jul 1933 [
=>
]
10
Clarissa Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.8]
b. Abt 1795 d. 1850
10
Catherine Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.9]
b. Abt 1796 d. Aft 1826
10
Nancy Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.2.10]
b. Abt 1797 d. Aft 1826
9
John Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.3]
b. Abt 1757 d. 6 Nov 1855
Mary Terry
b. 26 Jan 1775
10
William Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.3.1]
b. Abt 1797
10
Elizabeth Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.3.2]
b. Abt 1800
10
John R Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.3.3]
b. Abt 1803
10
Ann Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.3.4]
b. Abt 1809
+
Garner
b. Abt 1809
10
Sarah or Sally Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.1.3.5]
b. Abt 1812
8
Richard Bennett, Jr
[1.2.2.6.3.2.2.2]
b. Abt 1732
8
John Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.3]
b. Abt 1734 d. 18 Jul 1791
8
William Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.4]
b. Abt 1736
8
James Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.5]
b. Abt 1740
8
Fisher Rice Bennett
[1.2.2.6.3.2.2.6]
b. Abt 1743
6
Mary Rice
[1.2.2.6.3.3]
b. 9 Dec 1694 d. 1751
6
Edward Rice
[1.2.2.6.3.4]
b. 17 Apr 1690
Mary Claiborne
b. 9 Dec 1694 d. 1760
7
Charles Rice
[1.2.2.6.3.4.1]
b. 1715 d. 22 Nov 1785
Mary Holman
b. 1720 d. Abt 1802
8
Thomas Rice
[1.2.2.6.3.4.1.1]
b. 1732 d. 1804
Joyce Rice
b. 1735 d. 1804
9
Sarah Susannah Rice
[1.2.2.6.3.4.1.1.1]
b. 1753 d. 1850
Phillip Moses Francis Tackett
b. 1745 d. 1830
10
William Tackett
[1.2.2.6.3.4.1.1.1.1]
b. 12 May 1779 d. 22 Sep 1851
10
Lancaster Tackett
[1.2.2.6.3.4.1.1.1.2]
b. Abt 1780 d. 9 Jul 1848
Ellender Hampton
b. 1785 d. 16 Apr 1855
11
Abner Hampton Tackett
[1.2.2.6.3.4.1.1.1.2.1]
b. 6 Feb 1803 d. 20 Jun 1889
Celia Ann Butler
b. 12 Dec 1809 d. 28 Feb 1873
12
Elizabeth J Tackett
[1.2.2.6.3.4.1.1.1.2.1.1]
b. 30 Jul 1828
12
Eleanor Caroline Tackett
[1.2.2.6.3.4.1.1.1.2.1.2]
b. 29 Dec 1830 d. 21 Jul 1914
12
Sarah M Tackett
[1.2.2.6.3.4.1.1.1.2.1.3]
b. 28 Sep 1832 d. 5 Jan 1920
12
Syrena Belle Tackett
[1.2.2.6.3.4.1.1.1.2.1.4]
b. 21 Mar 1833 d. 5 Jan 1920
12
John Lancaster Tackett
[1.2.2.6.3.4.1.1.1.2.1.5]
b. 22 Feb 1837 d. 13 Mar 1923
12
Civillia Angeline Tackett
[1.2.2.6.3.4.1.1.1.2.1.6]
b. 1838
12
Abner Wilse Tackett
[1.2.2.6.3.4.1.1.1.2.1.7]
b. 24 Jan 1843 d. 12 Dec 1915
12
Samuel Elbert Tackett
[1.2.2.6.3.4.1.1.1.2.1.8]
b. 8 Oct 1848 d. 15 Feb 1920
12
Martha Tackett
[1.2.2.6.3.4.1.1.1.2.1.9]
b. 17 Mar 1851 d. 27 Apr 1896 [
=>
]
12
Sydney S Tackett
[1.2.2.6.3.4.1.1.1.2.1.10]
b. 17 Mar 1851 d. 1901
12
Celia Ann Tackett
[1.2.2.6.3.4.1.1.1.2.1.11]
b. 11 Apr 1854 d. 13 Jan 1919
12
Jerome Land Tackett
[1.2.2.6.3.4.1.1.1.2.1.12]
b. 1856 d. 1919
11
Elizabeth Tackett
[1.2.2.6.3.4.1.1.1.2.2]
b. Abt 1805
11
Sarah Tackett
[1.2.2.6.3.4.1.1.1.2.3]
b. 1809
10
George W Tackett
[1.2.2.6.3.4.1.1.1.3]
b. Abt 1780 d. 1835
10
Sarah Aley Tackett
[1.2.2.6.3.4.1.1.1.4]
b. 1781 d. 1817
8
Basil Rice
[1.2.2.6.3.4.1.2]
b. Abt 1745
8
Mary Molly Rice
[1.2.2.6.3.4.1.3]
b. 25 Jun 1746 d. 12 May 1788
8
Martha Rice
[1.2.2.6.3.4.1.4]
b. Abt 1747
8
Tandy Rice
[1.2.2.6.3.4.1.5]
b. Abt 1748 d. 5 Aug 1795
8
Sarah Sally Rice
[1.2.2.6.3.4.1.6]
b. 1749 d. 1817
8
Franky Rice
[1.2.2.6.3.4.1.7]
b. 3 Apr 1756 d. Bef 1785
8
Holman Rice
[1.2.2.6.3.4.1.8]
b. 1 Mar 1758 d. 16 Jan 1849
6
John Rice
[1.2.2.6.3.5]
b. 18 Sep 1698
6
Marcy Rice
[1.2.2.6.3.6]
b. 5 Jul 1702
6
David Rice
[1.2.2.6.3.7]
b. 1704
6
Charles Rice
[1.2.2.6.3.8]
b. 1705
6
Susannah Rice
[1.2.2.6.3.9]
b. 1707
4
James Rice
[1.2.2.7]
b. 1642 d. 1642
3
Edward Frost
[1.2.3]
b. 11 Nov 1605 d. 26 Jul 1616
3
Mary Frost
[1.2.4]
b. 1607 d. 1622
3
Thomas Frost
[1.2.5]
b. 21 Apr 1616