Home Page
|
What's New
|
Photos
|
Histories
|
Headstones
|
Reports
|
Surnames
Search
First Name:
Last Name:
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Suomalainen
Svenska
Sir Robert Innes, 2nd of Innermarky
1470 - 1551 (81 years)
Submit Photo / Document
Individual
Descendants
Relationship
Timeline
Submit Photo / Doc
Worksheet
Family
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Sir Robert Innes, 2nd of Innermarky
[1]
b. 1470 d. Oct 1551
Elizabeth Stewart
b. 1474 d. 25 Nov 1564
2
Robert Innes
[1.1]
b. Abt 1505
2
John Innes
[1.2]
b. 1509
Marjorie Leslie
b. 1520
3
Robert Innes
[1.2.1]
b. Abt 1542 d. 7 Dec 1595
Jean Barclay
b. Abt 1550 d. 19 Oct 1607
4
Elizabeth Innes
[1.2.1.1]
b. Abt 1575
William Mackintosh
b. 1567 d. Abt 1630
5
Lachlan McIntosh
[1.2.1.1.1]
b. Abt 1595 d. 1661
Helen Gordon
b. 1595 d. 28 Aug 1637
6
William MacIntosh
[1.2.1.1.1.1]
b. Abt 1625 d. 1716
Mary Baillie
b. Abt 1631
7
William MacIntosh
[1.2.1.1.1.1.1]
b. Abt 25 Mar 1650 d. 3 Dec 1685
Jael O'Sullivan
b. Abt 1649 d. 1685
8
Daniel Tosh
[1.2.1.1.1.1.1.1]
b. 16 Feb 1668 d. 1706
8
Sarah Tosh
[1.2.1.1.1.1.1.2]
b. 3 Feb 1669 d. 1717
8
Catherine Eshannah Tosh
[1.2.1.1.1.1.1.3]
b. 10 Jan 1672 d. Abt 1712
8
John Tosh
[1.2.1.1.1.1.1.4]
b. 20 Aug 1674 d. 1675
8
Bethia Tosh
[1.2.1.1.1.1.1.5]
b. Sep 1676 d. 28 Apr 1703
Ephraim Tiffany
b. 26 Dec 1677 d. 15 Jul 1727
9
Samuel Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.1]
b. 7 Apr 1701 d. 1734
9
Consider Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2]
b. 28 Apr 1703 d. 29 May 1763
Naomi Comstock
b. 1708 d. 29 May 1743
10
Consider Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.1]
b. 15 Mar 1732 d. 19 Jun 1796
Sarah Wilder
b. 13 Aug 1738 d. 7 Nov 1818
11
Jemima Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.1.1]
b. 12 Oct 1756 d. 24 Jul 1784
11
Ephriam Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.1.2]
b. 8 Nov 1758 d. 7 Apr 1818
11
Dorothy Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.1.3]
b. 19 Jun 1762 d. 7 Nov 1818
11
Levi Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.1.4]
b. 23 Apr 1766 d. 20 Nov 1851
11
Consider Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.1.5]
b. 12 Mar 1769 d. 4 Sep 1859
11
Betty Wilder Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.1.6]
b. 25 Feb 1772 d. 16 Feb 1837
11
Mary Willey Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.1.7]
b. 1 Apr 1775
11
Lewis Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.1.8]
b. Abt 1777 d. 13 Nov 1777
11
Dolly Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.1.9]
b. Abt 1779
10
Luther Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.2]
b. 15 Apr 1734
10
Naomi Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.3]
b. 28 Dec 1737 d. 25 Jul 1821
Ezekial Huntley
b. 9 Mar 1728 d. 25 Jul 1783
11
Rufus Huntley
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.3.1]
b. 18 Sep 1764 d. 4 Apr 1860
11
Lois Huntley
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.3.2]
b. 18 Sep 1764 d. 2 Feb 1848
11
Elias Huntley
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.3.3]
b. 28 Jul 1765 d. 10 Jan 1783
11
Asher Hulbert
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.3.4]
b. 1 Mar 1767 d. 1 Mar 1849
11
Naomi Huntley
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.3.5]
b. Abt 1768 d. 2 Dec 1840
11
Ezra Huntley
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.3.6]
b. 2 Jun 1771 d. 13 Apr 1817
11
Ezekiel Huntley, Jr
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.3.7]
b. 21 May 1780 d. 5 Mar 1853
10
Samuel Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4]
b. 13 Jul 1740 d. Mar 1822
Abigail Curtis
b. 17 Mar 1742 d. May 1820
11
Samuel Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.1]
b. 21 Oct 1761 d. 21 Apr 1851
Mary Sackett
b. Abt 1761 d. 1862
12
Samuel Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.1.1]
b. 1788 d. Abt 1845
12
Mary Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.1.2]
b. 1797
12
Julia Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.1.3]
b. 1799 d. 13 Jan 1891
12
Thomas Jefferson Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.1.4]
b. 1801
12
Hannah Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.1.5]
b. 5 Apr 1804 d. 10 Sep 1860
12
Calinda Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.1.6]
b. 2 Dec 1807 d. 5 Mar 1866
12
Ezekiel Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.1.7]
b. 1810
12
Jefferson Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.1.8]
b. Abt 1810
12
Harry Edward Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.1.9]
b. 25 Jun 1813 d. 14 Dec 1871
12
Harriet Emeline Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.1.10]
b. Abt 1815
12
Lorenzo Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.1.11]
b. Abt 1818
11
Nathanial Curtis Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.2]
b. 18 Feb 1762 d. 13 Feb 1857
Dency Crane
b. Abt 1765
12
Nathaniel Curtis Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.2.1]
b. Mar 1790
12
Harriet Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.2.2]
b. Mar 1792 d. 1858
12
Dancy Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.2.3]
b. 25 Sep 1795 d. 24 Mar 1846
12
Anron Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.2.4]
b. 2 Jun 1797 d. 27 Feb 1847
12
Betsey Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.2.5]
b. Abt 1799
12
David Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.2.6]
b. 1800
12
Mary Polly Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.2.7]
b. 17 Dec 1801 d. 20 May 1835
12
Elizabeth Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.2.8]
b. 1805
12
Caroline Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.2.9]
b. Abt 1807 d. 1843
11
Jemima Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.3]
b. 1763 d. 6 Mar 1848
Reuben Ward
b. 13 Nov 1748 d. 5 Jul 1825
12
Affa Ward
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.3.1]
b. 27 May 1783 d. 28 Feb 1877 [
=>
]
12
Reuben Ward
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.3.2]
b. Abt 1784 d. 5 Mar 1876
12
Jemima Ward
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.3.3]
b. Abt 1786
12
Laura Ward
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.3.4]
b. Abt 1790
12
Eda Ward
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.3.5]
b. Abt 1788
12
Samuel Ward
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.3.6]
b. Abt 1792 d. 23 Feb 1873
12
Dorcas Ward
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.3.7]
b. Abt 1794
12
Cynthia Ward
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.3.8]
b. Abt 1796
12
William B Ward
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.3.9]
b. 1801
12
Daniel Ward
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.3.10]
b. 1807
11
William Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.4]
b. Abt 1765
11
Emellason Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.5]
b. Abt 1765 d. 18 Mar 1847
Sarah Aldrich
b. 4 Apr 1773
12
Rhoda Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.5.1]
b. 1 Nov 1793
12
George Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.5.2]
b. 5 May 1794
12
Lemuel Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.5.3]
b. 30 Jun 1796
12
David Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.5.4]
b. 18 Aug 1798
12
Sarah Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.5.5]
b. 27 Mar 1803 d. 14 Nov 1838
12
Silas Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.5.6]
b. 13 Apr 1809
11
Daniel Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.6]
b. 18 Sep 1768 d. 25 Sep 1793
+
Phebe Rand
b. Abt 1770
11
Abigail Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.7]
b. Abt 1770
+
Zenos Aldrich
b. 1766 d. 8 Nov 1856
11
George Obediah Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.8]
b. 7 May 1772 d. 13 Feb 1857
Mary Mason
b. Abt 1766 d. 16 Mar 1840
12
Abigail Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.8.1]
b. Abt 1797 d. Dec 1859
12
Zilpha Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.8.2]
b. Abt 1799 d. 1830
12
Zenas Schovil Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.8.3]
b. 25 Jun 1801 d. 1822
12
Luther Little Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.8.4]
b. 28 Mar 1803 d. 17 Feb 1881
12
Frederick Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.8.5]
b. 1804 d. 1804
12
Lorenzo Mason Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.8.6]
b. Abt 1804 d. Abt 1809
12
Jane Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.8.7]
b. 14 Apr 1805 d. 26 Nov 1867
12
George Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.8.8]
b. 4 May 1808 d. 21 Jun 1885 [
=>
]
12
Lorenzo Roderick Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.8.9]
b. 4 Jul 1810 d. Abt 1810
12
Richard Mason Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.8.10]
b. 4 Jul 1810 d. 1897
12
Daniel Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.8.11]
b. 12 Sep 1812 d. 25 Jan 1894
12
Mary Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.8.12]
b. 28 Mar 1814 d. 1899
12
Phebe Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.8.13]
b. 24 Oct 1817 d. 20 Feb 1850
12
Larena Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.8.14]
b. 1818 d. 1844
12
Ann Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.8.15]
b. 4 Jun 1822 d. 12 Sep 1893
11
Mary Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.9]
b. 17 Jun 1777 d. 12 Sep 1845
Daniel Whipple
b. 27 Aug 1779 d. 27 Sep 1839
12
Cynthia Whipple
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.9.1]
b. 15 Jan 1805 d. 1889 [
=>
]
12
Samuel Whipple
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.9.2]
b. 21 Dec 1808 d. 9 Jan 1887 [
=>
]
12
Almira Whipple
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.9.3]
b. 13 Jun 1810 d. 4 Feb 1889 [
=>
]
12
Phoebe Whipple
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.9.4]
b. 13 Aug 1813 d. 18 Nov 1846 [
=>
]
12
Carum Whipple
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.9.5]
b. 12 Aug 1815 d. 1843
12
Gerua Whipple
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.9.6]
b. 12 Aug 1815 d. 18 Sep 1848
12
Nelson Wheeler Whipple
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.9.7]
b. 11 Jul 1818 d. 5 Jul 1887 [
=>
]
Zenos Aldrich
b. Abt 1773 d. 8 Nov 1856
12
Sylvanus Aldrich
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.9.8]
b. 1799 d. 8 Nov 1856
12
Azuba Aldrich
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.9.9]
b. Abt 1801 [
=>
]
11
Azuba Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.10]
b. 22 Aug 1779 d. 13 Nov 1865
Jared Patchen
b. 5 Sep 1773 d. 1 May 1857
12
Martin Ray Patchen
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.10.1]
b. 10 Feb 1799 d. 7 Feb 1842
12
Abigail Patchen
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.10.2]
b. 23 Jan 1801 d. 7 Sep 1823
12
Emily Patchen
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.10.3]
b. 1802 d. 16 Jul 1826
12
John Patchen
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.10.4]
b. 14 Jan 1803 d. 23 Oct 1874
12
Ira Patchen
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.10.5]
b. 10 Jun 1805
12
Polly Patchen
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.10.6]
b. 20 Jan 1808 d. 21 Aug 1891
12
Mary Patchen
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.10.7]
b. 20 Jan 1808 d. 23 Feb 1888
12
Jared Patchen
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.10.8]
b. 6 Sep 1812
12
Sylvanus Aldridge Patchen
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.10.9]
b. 27 Nov 1814 d. 10 Feb 1892
12
Azuba Ann Patchen
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.10.10]
b. 4 Jun 1817 d. 29 Sep 1886
12
Hannah Lavinia Patchen
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.10.11]
b. 24 Apr 1820
12
Samuel Lorenzo Patchen
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.10.12]
b. 1 Aug 1823 d. 14 Jun 1867
12
Amy Patchen
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.10.13]
b. Abt 5 Jul 1825
11
Phoebe Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.11]
b. 22 Aug 1781 d. 31 Dec 1855
Nathan S Stewart
b. 7 Mar 1771 d. 7 Aug 1866
12
Horace S Stewart
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.11.1]
b. 15 Jun 1804 d. 7 Aug 1866
12
Erastus A Stewart
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.11.2]
b. 10 Mar 1805 d. 10 Nov 1851
12
Elijah Burr Stewart
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.11.3]
b. Abt 1809 d. 9 Nov 1880
12
Azuba Ann Stewart
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.11.4]
b. 1810
12
Samuel Curtis Stewart
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.11.5]
b. 1811 d. 25 Nov 1870
12
William Stewart
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.11.6]
b. 1812
12
Azubam Stewart
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.11.7]
b. 1812
12
Thomas Ryler Stewart
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.11.8]
b. 1815
11
Amy Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.12]
b. 8 Dec 1783 d. 17 Dec 1857
Isaac Darrow
b. Abt 1779
12
John Tiffany Darrow
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.12.1]
b. 17 Nov 1800 d. 13 Nov 1897
12
Affa Ward Darrow
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.12.2]
b. 26 Dec 1803 d. 15 Apr 1875
12
Hannah Mead Darrow
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.12.3]
b. 24 Apr 1806
12
Mary Cromwell Darrow
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.12.4]
b. 9 May 1808 d. 18 Nov 1877
12
Ann Hubbard Darrow
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.12.5]
b. 27 Mar 1811 d. 24 Jul 1890
12
Susan Pardee Darrow
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.4.12.6]
b. 1813 d. 24 Jun 1890
10
Humphery Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.5]
b. 2 Mar 1742 d. 1831
Phebe Brown
b. Abt 1751 d. 1831
11
Lydia "Lidda" Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.5.1]
b. 13 May 1772 d. 1 Jul 1856
11
Susanna Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.5.2]
b. 28 Feb 1774
11
John C Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.5.3]
b. 17 Dec 1776 d. 9 Jul 1855
11
William Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.5.4]
b. Abt 1781 d. 12 Oct 1866
11
Phebe Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.5.5]
b. 1783
11
Humphrey Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.5.6]
b. 13 Sep 1788 d. 24 Jun 1870
11
Nelson Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.2.5.7]
b. 13 Sep 1808 d. 7 Sep 1869
9
Humphrey Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.3]
b. 7 Feb 1706 d. 7 Feb 1706
9
Ephraim Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.4]
b. 1707
9
Bethia Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.5]
b. Abt 1710
9
Mary Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.6]
b. Abt 1714
9
Ebenezer Tiffany
[1.2.1.1.1.1.1.5.7]
b. 1716 d. 13 Feb 1799
8
James Tosh
[1.2.1.1.1.1.1.6]
b. 6 Sep 1679
7
Lachlan MacIntosh
[1.2.1.1.1.1.2]
b. Abt 1652
7
Lydia MacIntosh
[1.2.1.1.1.1.3]
b. Abt 1653
7
Duncan MacIntosh
[1.2.1.1.1.1.4]
b. Abt 1656
7
Joseph MacIntosh
[1.2.1.1.1.1.5]
b. Abt 1657
5
Robert Mackintosh
[1.2.1.1.2]
b. Abt 1602
5
William Mackintosh
[1.2.1.1.3]
b. Abt 1606