Home Page
|
What's New
|
Photos
|
Histories
|
Headstones
|
Reports
|
Surnames
Search
First Name:
Last Name:
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Suomalainen
Svenska
John Bancroft
1596 - 1637 (41 years)
Submit Photo / Document
Individual
Descendants
Relationship
Timeline
Submit Photo / Doc
Worksheet
Family
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
John Bancroft
[1]
b. 1596 d. 1637
Janae Hales
b. Abt 1601
2
Sarah Bancroft
[1.1]
b. 19 Mar 1619 d. 10 May 1685
John Stratton
b. 14 Aug 1621 d. 30 Aug 1684
3
Sarah Stratton
[1.1.1]
b. 1647 d. 1684
Stephen Hand
b. 1635 d. 16 Apr 1693
4
Joseph Hand
[1.1.1.1]
b. 1664 bur. 8 Jul 1713
4
Abigail Hand
[1.1.1.2]
b. 1667 d. 18 Apr 1747
4
Samuel Hand
[1.1.1.3]
b. 27 Jan 1672 d. 1735
Elizabeth Bishop
b. 1668 d. 1700
5
Nehemiah Hand
[1.1.1.3.1]
b. 1700 d. 27 Dec 1775
Lydia Umn
b. 1701 d. 9 Nov 1776
6
Hezekiah Hand
[1.1.1.3.1.1]
b. 1726 d. 7 Apr 1800
6
Samuel Hand
[1.1.1.3.1.2]
b. 1728 d. 1817
Phebe Lum
b. 25 May 1737 d. 1788
7
Daughter Hand
[1.1.1.3.1.2.1]
b. 23 Sep 1759
7
Obadiah Hand
[1.1.1.3.1.2.2]
b. 22 Dec 1760 d. 7 Aug 1837
7
Hannah Hand
[1.1.1.3.1.2.3]
b. 21 Jun 1761
7
Phebe Hand
[1.1.1.3.1.2.4]
b. 15 Apr 1767 d. 22 Jun 1854
Cornelius van Derbilt
b. 28 Aug 1764 d. 20 May 1832
8
Mary Vanderbilt
[1.1.1.3.1.2.4.1]
b. 1787 d. 10 Aug 1845
8
Jacob Vanderbilt
[1.1.1.3.1.2.4.2]
b. 1789 d. 3 Oct 1805
8
Charlotte Vanderbilt
[1.1.1.3.1.2.4.3]
b. 7 May 1792 d. 5 Jan 1877
8
Commodore Cornelius Vanderbilt
[1.1.1.3.1.2.4.4]
b. 27 May 1794 d. 4 Jan 1877
Sophia Johnson
b. 7 May 1795 d. 17 Aug 1868
9
Phebe Jane Vanderbilt
[1.1.1.3.1.2.4.4.1]
b. Dec 1815 d. 6 Jul 1878
9
Ethelinda Vanderbilt
[1.1.1.3.1.2.4.4.2]
b. 8 Mar 1818 d. 25 Feb 1889
9
Elizabeth Vanderbilt
[1.1.1.3.1.2.4.4.3]
b. 30 May 1819 d. 1890
9
William Henry "Billy" Vanderbilt
[1.1.1.3.1.2.4.4.4]
b. 8 May 1821 d. 8 Dec 1885
Maria Louisa Kissam
b. 24 Jun 1821 d. 6 Nov 1896
10
Cornelius Vanderbilt
[1.1.1.3.1.2.4.4.4.1]
b. 27 Nov 1843 d. 12 Sep 1899
10
Margaret Louisa Vanderbilt
[1.1.1.3.1.2.4.4.4.2]
b. 23 Jul 1845 d. 3 Mar 1924
10
William Kissam Vanderbilt
[1.1.1.3.1.2.4.4.4.3]
b. 12 Dec 1849 d. 22 Jul 1920
10
Emily Thorn Vanderbilt
[1.1.1.3.1.2.4.4.4.4]
b. Abt 1851 d. 29 Jul 1946
10
Florence Adele Vanderbilt
[1.1.1.3.1.2.4.4.4.5]
b. 8 Jan 1854 d. 11 Apr 1952
10
Frederick William Vanderbilt
[1.1.1.3.1.2.4.4.4.6]
b. 2 Feb 1856 d. 29 Jun 1938
10
Eliza Osgood Vanderbilt
[1.1.1.3.1.2.4.4.4.7]
b. 20 Sep 1860 d. 10 Jul 1936
10
George Washington Vanderbilt
[1.1.1.3.1.2.4.4.4.8]
b. 14 Nov 1862 d. 6 Mar 1914
9
Emily Almira Vanderbilt
[1.1.1.3.1.2.4.4.5]
b. 6 Jun 1823 d. 5 Dec 1896
9
Sophia Johnson Vanderbilt
[1.1.1.3.1.2.4.4.6]
b. 9 Mar 1825 d. 24 Feb 1912
9
Maria Louisa Vanderbilt
[1.1.1.3.1.2.4.4.7]
b. 8 May 1827 d. 1896
9
Frances Lavinia Vanderbilt
[1.1.1.3.1.2.4.4.8]
b. 8 Dec 1828 d. 1868
9
Cornelius Jeremiah Vanderbilt
[1.1.1.3.1.2.4.4.9]
b. 29 Dec 1830 d. 2 Apr 1882
9
George Washington Vanderbilt
[1.1.1.3.1.2.4.4.10]
b. 23 Sep 1832 d. 16 Nov 1836
9
Mary Alicia Vanderbilt
[1.1.1.3.1.2.4.4.11]
b. 25 Apr 1833 d. 16 Aug 1902
9
Catharine Juliette Vanderbilt
[1.1.1.3.1.2.4.4.12]
b. 23 Aug 1836 d. 8 Aug 1881
9
George Washington Vanderbilt
[1.1.1.3.1.2.4.4.13]
b. 10 Apr 1839 d. 1864
+
Frank Armstrong Crawford
b. 18 Jan 1839 d. 4 May 1885
8
Jane Vanderbilt
[1.1.1.3.1.2.4.5]
b. 14 Nov 1800 d. 1866
8
Eleanor Vanderbilt
[1.1.1.3.1.2.4.6]
b. 4 Jan 1804 d. 1833
8
Jacob Hand Vanderbilt
[1.1.1.3.1.2.4.7]
b. 2 Sep 1807 d. 1893
7
Elizabeth Hand
[1.1.1.3.1.2.5]
b. Apr 1770 d. 13 Nov 1841
Nathaniel Johnson
b. 18 Aug 1765 d. 1804
8
Sophia Johnson
[1.1.1.3.1.2.5.1]
b. 7 May 1795 d. 17 Aug 1868
Commodore Cornelius Vanderbilt
b. 27 May 1794 d. 4 Jan 1877
9
Phebe Jane Vanderbilt
[1.1.1.3.1.2.5.1.1]
b. Dec 1815 d. 6 Jul 1878
9
Ethelinda Vanderbilt
[1.1.1.3.1.2.5.1.2]
b. 8 Mar 1818 d. 25 Feb 1889
9
Elizabeth Vanderbilt
[1.1.1.3.1.2.5.1.3]
b. 30 May 1819 d. 1890
9
William Henry "Billy" Vanderbilt
[1.1.1.3.1.2.5.1.4]
b. 8 May 1821 d. 8 Dec 1885
Maria Louisa Kissam
b. 24 Jun 1821 d. 6 Nov 1896
10
Cornelius Vanderbilt
[1.1.1.3.1.2.5.1.4.1]
b. 27 Nov 1843 d. 12 Sep 1899
10
Margaret Louisa Vanderbilt
[1.1.1.3.1.2.5.1.4.2]
b. 23 Jul 1845 d. 3 Mar 1924
10
William Kissam Vanderbilt
[1.1.1.3.1.2.5.1.4.3]
b. 12 Dec 1849 d. 22 Jul 1920
10
Emily Thorn Vanderbilt
[1.1.1.3.1.2.5.1.4.4]
b. Abt 1851 d. 29 Jul 1946
10
Florence Adele Vanderbilt
[1.1.1.3.1.2.5.1.4.5]
b. 8 Jan 1854 d. 11 Apr 1952
10
Frederick William Vanderbilt
[1.1.1.3.1.2.5.1.4.6]
b. 2 Feb 1856 d. 29 Jun 1938
10
Eliza Osgood Vanderbilt
[1.1.1.3.1.2.5.1.4.7]
b. 20 Sep 1860 d. 10 Jul 1936
10
George Washington Vanderbilt
[1.1.1.3.1.2.5.1.4.8]
b. 14 Nov 1862 d. 6 Mar 1914
9
Emily Almira Vanderbilt
[1.1.1.3.1.2.5.1.5]
b. 6 Jun 1823 d. 5 Dec 1896
9
Sophia Johnson Vanderbilt
[1.1.1.3.1.2.5.1.6]
b. 9 Mar 1825 d. 24 Feb 1912
9
Maria Louisa Vanderbilt
[1.1.1.3.1.2.5.1.7]
b. 8 May 1827 d. 1896
9
Frances Lavinia Vanderbilt
[1.1.1.3.1.2.5.1.8]
b. 8 Dec 1828 d. 1868
9
Cornelius Jeremiah Vanderbilt
[1.1.1.3.1.2.5.1.9]
b. 29 Dec 1830 d. 2 Apr 1882
9
George Washington Vanderbilt
[1.1.1.3.1.2.5.1.10]
b. 23 Sep 1832 d. 16 Nov 1836
9
Mary Alicia Vanderbilt
[1.1.1.3.1.2.5.1.11]
b. 25 Apr 1833 d. 16 Aug 1902
9
Catharine Juliette Vanderbilt
[1.1.1.3.1.2.5.1.12]
b. 23 Aug 1836 d. 8 Aug 1881
9
George Washington Vanderbilt
[1.1.1.3.1.2.5.1.13]
b. 10 Apr 1839 d. 1864
8
Cornelius Johnson
[1.1.1.3.1.2.5.2]
b. 3 Oct 1798
8
Nathaniel Charles Johnson
[1.1.1.3.1.2.5.3]
b. 4 Jul 1802 d. 16 Oct 1873
7
Susannah Hand
[1.1.1.3.1.2.6]
b. 16 Aug 1771 d. 5 Jul 1811
6
Benjamin Hand
[1.1.1.3.1.3]
b. 1730 d. 1772
6
Nehemiah Hand
[1.1.1.3.1.4]
b. 1733
6
Stephen Hand
[1.1.1.3.1.5]
b. 12 Jul 1734 d. 15 Jun 1821
6
Abraham Hand
[1.1.1.3.1.6]
b. 1736 d. 15 Dec 1760
6
Daniel Hand
[1.1.1.3.1.7]
b. 1738 d. 1 Jan 1777
6
Phoebe Hand
[1.1.1.3.1.8]
b. 1740
6
John Hand
[1.1.1.3.1.9]
b. 1742
4
Elizabeth Hand
[1.1.1.4]
b. 27 Jan 1672 d. 1711
4
Esther Hand
[1.1.1.5]
b. Abt 1675
3
Joseph Stratton
[1.1.2]
b. 1649 d. 23 Dec 1722
3
Hannah Stratton
[1.1.3]
b. 1649 d. 21 Jan 1670
3
Stephen Stratton
[1.1.4]
b. Abt 1651 d. 8 Apr 1697
3
Cornelius Stratton
[1.1.5]
b. Abt 1653 d. 27 Mar 1704
3
Ruth Stratton
[1.1.6]
b. 30 Aug 1653 d. 22 Nov 1739
3
Rebecca Stratton
[1.1.7]
b. Abt 1654 d. 18 May 1703
2
Elizabeth Bancroft
[1.2]
b. 1620 d. 20 May 1704
2
John Bancroft
[1.3]
b. Abt 1622
2
Thomas Bancroft
[1.4]
b. 10 Feb 1625 d. 14 Dec 1684
Margaret Wright
b. 1634 d. 17 Dec 1699
3
Margritt Bancraft
[1.4.1]
b. 16 Aug 1656
3
Anna Bancroft
[1.4.2]
b. 1 Jul 1658 d. 30 Jun 1659
3
Thomas Bancroft
[1.4.3]
b. 21 Nov 1659
Margaret Miller
b. Abt 1663
4
Nathaniel Bancroft
[1.4.3.1]
b. 24 Oct 1683 d. 10 Feb 1724
3
Anna Bancroft
[1.4.4]
b. 5 May 1663 d. 16 Mar 1733
Thomas Gilbert
b. 15 Mar 1659 d. 14 May 1698
4
Ebenezer Gilbert
[1.4.4.1]
b. 4 Jan 1692 d. 4 Jan 1692
4
Margaret Gilbert
[1.4.4.2]
b. 27 Mar 1693 d. 15 Nov 1755
4
Sarah Gilbert
[1.4.4.3]
b. 18 Jan 1694
4
Anna Gilbert
[1.4.4.4]
b. 16 Feb 1696
James Sexton
b. 29 Apr 1655 d. 12 Dec 1741
4
James Sexton
[1.4.4.5]
b. 9 Nov 1702 d. 12 Jun 1783
4
Catherine Sexton
[1.4.4.6]
c. 17 Dec 1704 d. 11 Oct 1793
3
Lydia Bancroft
[1.4.5]
b. 6 Feb 1665
3
Julia Bancroft
[1.4.6]
b. 1666 d. 30 Jul 1666
3
Ruth Bancroft
[1.4.7]
b. 9 Aug 1670 d. 1714
John Stiles
b. 10 Nov 1665 d. 20 May 1753
4
Ruth Stiles
[1.4.7.1]
b. 5 Feb 1691 d. 11 Dec 1760
Nathaniel Taylor
b. 20 May 1688 d. 6 May 1736
5
Ruth Taylor
[1.4.7.1.1]
b. 3 Apr 1712
Simon Pearson
b. 7 Nov 1709
6
Ruth Pearson
[1.4.7.1.1.1]
b. 21 Oct 1739
6
Benjamin Person
[1.4.7.1.1.2]
b. 21 May 1742
6
Ezra Pearson
[1.4.7.1.1.3]
b. 16 Apr 1744 d. 30 Dec 1800
Anne Fuller
b. 1741 d. Aft 1810
7
Lucinda Pearson
[1.4.7.1.1.3.1]
b. 29 Jan 1767
+
Ezekiel Barton
b. Abt 1767
7
Lieutenant Adin Pearson
[1.4.7.1.1.3.2]
b. 28 Nov 1768 d. 7 Jun 1853
Eunice Brooks
b. 3 Oct 1771 d. 24 Nov 1801
8
Lucina Pearson
[1.4.7.1.1.3.2.1]
b. 16 Jul 1789 d. 6 Sep 1878
Jonathan Harvey Andrus
b. 18 Feb 1783 d. 18 Jan 1875
9
Orrin Clark Andrus
[1.4.7.1.1.3.2.1.1]
b. 9 Dec 1807 d. 19 May 1885
Angeline Parsons
b. 24 Mar 1816 d. 28 Feb 1849
10
Orrin George Andrus
[1.4.7.1.1.3.2.1.1.1]
b. 23 Nov 1835 d. 17 Sep 1846
10
Olive Jane Andrus
[1.4.7.1.1.3.2.1.1.2]
b. 15 May 1838 d. 13 Dec 1922
Curtis Parkhurst Graves
b. 19 Aug 1831 d. 13 Jan 1878
11
George Frank Graves
[1.4.7.1.1.3.2.1.1.2.1]
b. 21 Dec 1862
Mary Emily Robberts
b. 29 Aug 1872
12
Olive J Graves
[1.4.7.1.1.3.2.1.1.2.1.1]
b. Nov 1899 d. 30 Nov 1990
12
Daniel Curtis Graves
[1.4.7.1.1.3.2.1.1.2.1.2]
b. 18 Oct 1901 d. 10 Apr 1982
12
May Ella Graves
[1.4.7.1.1.3.2.1.1.2.1.3]
b. 1905 d. 1909
11
Harriet Lillian Graves
[1.4.7.1.1.3.2.1.1.2.2]
b. 22 Aug 1864
+
Joseph Lefeber
b. 19 Oct 1856 d. 15 Jan 1940
11
Fred Curtis Graves
[1.4.7.1.1.3.2.1.1.2.3]
b. 10 Jun 1867
Eliza Dalling Anderson
12
Frederick William Graves
[1.4.7.1.1.3.2.1.1.2.3.1]
b. 30 Oct 1900
12
Murtle M Graves
[1.4.7.1.1.3.2.1.1.2.3.2]
b. 1904
11
Maggie C Graves
[1.4.7.1.1.3.2.1.1.2.4]
b. 30 Aug 1876
10
Charlotte Pope Andrus
[1.4.7.1.1.3.2.1.1.3]
b. 2 Nov 1841 d. 17 Apr 1853
10
John Parsons Andrus
[1.4.7.1.1.3.2.1.1.4]
b. 11 Jul 1844 d. 20 Nov 1915
Lucy Jane North
b. 23 Dec 1845 d. 5 Sep 1915
11
Carrie Angeline Andrus
[1.4.7.1.1.3.2.1.1.4.1]
b. 6 Dec 1864 d. 21 Feb 1865
11
Orrin Clark Andrus
[1.4.7.1.1.3.2.1.1.4.2]
b. 15 Feb 1868
11
Laura Frances Andrus
[1.4.7.1.1.3.2.1.1.4.3]
b. 29 Jan 1870
11
Lydia Maria Andrus
[1.4.7.1.1.3.2.1.1.4.4]
b. 20 Feb 1874
11
Alice Mae Andrus
[1.4.7.1.1.3.2.1.1.4.5]
b. 10 Jan 1876 d. 5 Dec 1942
Thomas Wilson Dyches
b. 29 Jun 1872 d. 17 Aug 1943
12
Robert Augustus Dyches
[1.4.7.1.1.3.2.1.1.4.5.1]
b. 13 Jun 1915 d. Oct 1970
11
Annie Andrus
[1.4.7.1.1.3.2.1.1.4.6]
b. 13 Feb 1879 d. 23 Jun 1903
Josiah Aiken Lee
b. 23 Jun 1866 d. 7 Feb 1947
12
Josiah Aiken Lee
[1.4.7.1.1.3.2.1.1.4.6.1]
b. 23 Jun 1903 d. 25 Jan 1985
10
George Henry Andrus
[1.4.7.1.1.3.2.1.1.5]
b. 8 Aug 1846 d. 12 May 1854
10
Angeline Andrus
[1.4.7.1.1.3.2.1.1.6]
b. 22 Feb 1849 d. 12 Mar 1849
+
Cynthia Martin
b. 17 Jul 1809 d. 4 Mar 1884
9
Pamelia Andrus
[1.4.7.1.1.3.2.1.2]
b. 21 Oct 1809 d. 14 Sep 1877
Ezra Taft Benson
b. 22 Feb 1811 d. 3 Sep 1869
10
Charles Agustus Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.2.1]
b. 26 Sep 1832 d. 14 Oct 1833
10
Chloe Jane Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.2.2]
b. 1835 d. 1835
10
Charles Augustus Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.2.3]
b. 9 Jul 1837 d. 18 Feb 1873
10
Jonathan Parsons Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.2.4]
b. Mar 1841 d. Mar 1841
10
Adin Parsons Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.2.5]
b. Mar 1841 d. Mar 1841
10
Pamelia Emma Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.2.6]
b. 28 Feb 1842 d. 10 Feb 1892
10
Harvey Andrus Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.2.7]
b. 26 Sep 1844 d. 26 Sep 1844
10
Isabella Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.2.8]
b. 9 Mar 1846 d. 10 Feb 1922
10
Charlotte Taft Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.2.9]
b. 4 Jul 1850 d. 30 Nov 1918
Winfield Scott Norcross
b. 16 Jul 1844 d. 7 Jan 1915
11
Irving Norcross
[1.4.7.1.1.3.2.1.2.9.1]
b. 1880
11
Winfield Irvin Norcross
[1.4.7.1.1.3.2.1.2.9.2]
b. 18 Jun 1884
9
Adeline Brooks Andrus
[1.4.7.1.1.3.2.1.3]
b. 18 Mar 1813 d. 20 Apr 1898
Ezra Taft Benson
b. 22 Feb 1811 d. 3 Sep 1869
10
George Taft Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1]
b. 1 May 1846 d. 16 May 1919
Louisa Alexandrine Ballif
b. 25 Feb 1850 d. 7 Feb 1922
11
Louisa "Lulu" Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.1]
b. 28 Mar 1869 d. 15 Jul 1938
William Chandler Parkinson
b. 2 Aug 1855 d. 18 Nov 1929
12
Louisa Benson Parkinson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.1.1]
b. 5 Jul 1889 d. 12 Sep 1973 [
=>
]
12
Marie Benson Parkinson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.1.2]
b. 13 Dec 1891 d. 22 Jan 1919
12
Charlotte Benson Parkinson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.1.3]
b. 16 Jul 1894 d. 13 Oct 1980
12
Clara Parkinson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.1.4]
b. 8 Aug 1897 d. 6 Oct 1992 [
=>
]
12
George Benson Parkinson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.1.5]
b. 17 Oct 1899 d. 31 Oct 1918
12
Adeline Parkinson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.1.6]
b. 2 Jan 1902 d. 27 Apr 1990 [
=>
]
12
Wilbur Chandler Parkinson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.1.7]
b. 10 Oct 1904 d. 20 Dec 1988 [
=>
]
12
Carmen Parkinson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.1.8]
b. 5 Oct 1907 d. 24 Mar 1993 [
=>
]
12
Evelyn Parkinson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.1.9]
b. 30 Mar 1910 d. 30 Jun 1991
12
Wanda Parkinson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.1.10]
b. 31 Jul 1911 d. 13 Jun 1995 [
=>
]
11
Ezra Taft Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.2]
b. 6 Aug 1871 d. 28 Aug 1871
11
Elise Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.3]
b. 10 Mar 1873 d. 22 Aug 1937
George Alfred Alder, Jr
b. 4 Jan 1874 d. 3 May 1940
12
Ione Benson Alder
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.3.1]
b. 9 Jul 1896 d. 6 Oct 1983 [
=>
]
12
Lydia Dunford Alder
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.3.2]
b. 30 Nov 1898 d. 7 Aug 1983
12
Linden Benson Alder
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.3.3]
b. 20 Mar 1900 d. 8 Aug 1957 [
=>
]
12
Garold Benson Alder
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.3.4]
b. 2 May 1902 d. 12 Jun 1960 [
=>
]
12
George Benson Alder
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.3.5]
b. 1 May 1906 d. 11 Nov 1974 [
=>
]
12
Ballif Benson Alder
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.3.6]
b. 1 May 1906 d. 23 Nov 1906
12
Donald Benson Alder
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.3.7]
b. 4 Dec 1908 d. 14 Mar 1993 [
=>
]
12
George Alfred Alder
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.3.8]
b. 9 Jul 1912 d. 29 Mar 1913
11
George Taft Benson, Jr
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.4]
b. 24 Jun 1875 d. 13 Aug 1934
Sarah Sophia Dunkley
b. 29 Jun 1878 d. 1 Jun 1933
12
Ezra Taft Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.4.1]
b. 4 Aug 1899 d. 30 May 1994 [
=>
]
12
Joseph Dunkley Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.4.2]
b. 12 Nov 1900 d. 24 Apr 1936 [
=>
]
12
Margaret Dunkley Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.4.3]
b. 16 Feb 1902 d. 3 Jul 1999 [
=>
]
12
Orval Dunkley Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.4.4]
b. 30 Aug 1903 d. 1 Jul 1991 [
=>
]
12
Louisa Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.4.5]
b. 10 Oct 1905 d. 2 Jul 1996 [
=>
]
12
Lera Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.4.6]
b. 4 May 1907 d. 10 Jun 2009 [
=>
]
12
Valdo Dunkley Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.4.7]
b. 23 Apr 1911 d. 30 Oct 1990 [
=>
]
12
George Taft Benson, III
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.4.8]
b. 27 Aug 1912 d. 15 Apr 1990 [
=>
]
12
Sarah Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.4.9]
b. 30 Sep 1914 d. 26 Sep 2001 [
=>
]
12
Ross Dean Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.4.10]
b. 20 Jan 1917 d. 23 Oct 1985
12
Volco Ballif Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.4.11]
b. 11 Apr 1920 d. 13 Mar 1992
+
Clara Maria Danielsen
b. 10 Feb 1892 d. 20 Oct 1958
11
Serge Ballif Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.5]
b. 2 Oct 1877 d. 18 Jan 1959
Melinda Caroline Nelson
b. 8 Sep 1881 d. 27 Jun 1971
12
Sergene Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.5.1]
b. 7 Aug 1904 d. 23 Jun 1995 [
=>
]
12
Serge Nelson Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.5.2]
b. 15 Mar 1906 d. 28 Oct 1994 [
=>
]
12
Constance Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.5.3]
b. 24 Apr 1908 d. 23 Jul 1981 [
=>
]
12
Donna Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.5.4]
b. 16 Mar 1910 d. 5 Dec 1997 [
=>
]
12
Fae Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.5.5]
b. 14 Feb 1914 d. 9 Oct 1968
12
Zetta Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.5.6]
b. 20 Aug 1916 d. 6 Sep 2013 [
=>
]
12
Theodore Nelson Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.5.7]
b. 1 Apr 1919 d. 27 Jan 2006 [
=>
]
12
Jacqueline Maurie Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.5.8]
b. 17 May 1925 d. 23 Apr 2019
11
Adeline Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.6]
b. 31 Jul 1879 d. 27 Jan 1960
Leo Peck
b. 28 Jun 1875 d. 12 Oct 1967
12
Florence Peck
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.6.1]
b. 1 May 1901 d. 23 Apr 1991 [
=>
]
12
Effie Peck
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.6.2]
b. 8 Feb 1903 d. 21 Jul 1992 [
=>
]
12
Leo Benson Peck
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.6.3]
b. 20 Jul 1905 d. 18 Nov 1917
12
Maurine Peck
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.6.4]
b. 22 Nov 1907 d. 4 Aug 1935 [
=>
]
12
Beth Peck
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.6.5]
b. 24 Sep 1912 d. 8 Sep 2000
12
Garth Benson Peck
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.6.6]
b. 18 Apr 1916 d. 14 Dec 1993
12
Olive Louise Peck
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.6.7]
b. 22 Jun 1920 d. 24 Aug 1993 [
=>
]
11
Florence Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.7]
b. 31 Jul 1879 d. 5 Nov 1967
Stanley Detlef Jonasson
b. 4 Mar 1878 d. 8 May 1959
12
Adeline Jonasson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.7.1]
b. 5 Nov 1906 d. 23 Jul 1975
12
Stanley Taft Jonasson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.7.2]
b. 29 Aug 1908 d. 9 Dec 1986
12
Helen Jonasson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.7.3]
b. 27 Sep 1910 d. 17 Oct 1931
12
Dorothy Jonasson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.7.4]
b. 1912 d. 1912
12
Alfred Benson ( Bill ) Jonasson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.7.5]
b. 26 Feb 1919 d. 16 Dec 2000
11
William Kennedy Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.8]
b. 9 Feb 1882 d. 28 Feb 1882
11
Frank Taft Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.9]
b. 23 Apr 1883 d. 19 Feb 1923
Elizabeth Greaves "Lillie" Eames
b. 6 Jun 1884 d. 28 Dec 1966
12
Gladys Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.9.1]
b. 12 Nov 1909 d. 27 Jan 1995 [
=>
]
12
Carmen Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.9.2]
b. 4 Nov 1911 d. 17 Aug 2001 [
=>
]
12
Harold Eames Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.9.3]
b. 4 Nov 1911 d. 20 Jul 1948 [
=>
]
12
Flora Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.9.4]
b. 30 Jan 1916 d. 14 Oct 1984 [
=>
]
12
Zenda Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.9.5]
b. 25 Oct 1918 d. 27 Feb 2003 [
=>
]
12
Frank Eames Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.9.6]
b. 26 Sep 1920 d. 2 Jan 1923
12
Nellie Louisa Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.9.7]
b. 11 Sep 1923 d. 11 Oct 1975 [
=>
]
11
Marie Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.10]
b. 19 Jul 1885 d. 6 Mar 1891
11
Carmen Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.11]
b. 7 Nov 1887 d. 5 Jul 1974
Franklin Brenneman Smith, Jr
b. Abt 1860 d. 11 Apr 1954
12
Franklin Breneman Smith, III
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.11.1]
b. 11 Jun 1923 d. 3 Apr 2009
12
Richard Benson Smith
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.11.2]
b. 15 Jun 1925 d. 8 Dec 2009
11
Jenny Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.12]
b. 30 Jun 1890 d. 12 Jul 1970
Earl Weaver
b. 22 Jun 1890 d. 11 Oct 1977
12
Kinnie Weaver
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.12.1]
b. 30 May 1916 d. 27 Aug 1999
12
Virginia Weaver
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.12.2]
b. 23 Dec 1917 d. 2012 [
=>
]
12
Mary Louise "Louie" Weaver
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.12.3]
b. 15 Jun 1921 d. 16 May 2012 [
=>
]
12
Earl Benson Weaver
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.12.4]
b. 27 Oct 1926 d. 1 Jan 2015 [
=>
]
12
Jenalee Weaver
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.12.5]
b. 1929 d. Aug 2015
11
Kathinka "Kinnie" Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.13]
b. 15 Mar 1894 d. 20 May 1960
Robert Sweeten Holbrook
b. 14 Oct 1893 d. 2 Jun 1980
12
Robert Benson Holbrook
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.13.1]
b. 5 Aug 1917 d. 29 Feb 2000 [
=>
]
12
George Benson Holbrook
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.13.2]
b. 3 Nov 1919 d. 7 Nov 2009 [
=>
]
12
Louise Holbrook
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.13.3]
b. 4 Jun 1912 d. 27 May 2009 [
=>
]
12
Donald Benson Holbrook
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.13.4]
b. 4 Feb 1925 d. 1 Mar 2005 [
=>
]
12
Gordon Benson Holbrook
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.1.13.5]
b. 22 Dec 1926 d. 2 Nov 1993 [
=>
]
10
Florence Adeline Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.2]
b. 17 Sep 1851 d. 25 Dec 1852
10
Nellie Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.3]
b. 30 Nov 1851 d. 24 Jan 1885
10
Frank Andrus Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.4]
b. 16 Oct 1853 d. 5 May 1937
Amanda Charlotta Eliason
b. 4 Jun 1861 d. 12 Mar 1922
11
Eva A Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.4.1]
b. 6 Jul 1882 d. 10 Aug 1946
11
Blanche Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.4.2]
b. 7 May 1888 d. 12 Sep 1979
11
Edna Mae Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.4.3]
b. 19 Oct 1890 d. 19 Mar 1976
11
Frank Andrus Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.4.4]
b. 30 Apr 1895 d. 18 Dec 1968
11
Eleanora Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.4.5]
b. 30 Nov 1896 d. 2 Oct 1992
11
Karl Eliason Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.4.6]
b. 21 Apr 1899 d. 21 Oct 1980
11
Adeline Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.4.7]
b. 14 Mar 1904 d. 5 May 1904
11
George Taft Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.4.8]
b. 17 Aug 1905 d. 18 Feb 1942
10
Samuel Benson
[1.4.7.1.1.3.2.1.3.5]
b. 1853
9
Walter Harvey Andrus
[1.4.7.1.1.3.2.1.4]
b. 3 Feb 1815 d. 24 Jan 1898
9
Lucina Andrus
[1.4.7.1.1.3.2.1.5]
b. 24 Jul 1817 d. 27 Mar 1891
Walter Lackey
b. 1818 d. 21 Jan 1884
10
Frederick Percy Lackey
[1.4.7.1.1.3.2.1.5.1]
b. Abt 1840
10
Florence Adelia Lackey
[1.4.7.1.1.3.2.1.5.2]
b. 8 Nov 1840 d. 25 Jun 1909
10
Fanny Maria Lackey
[1.4.7.1.1.3.2.1.5.3]
b. 3 Sep 1843
10
Imogene Catharine Lackey
[1.4.7.1.1.3.2.1.5.4]
b. 1847 d. 31 Jul 1897
9
Adin Parsons Andrus
[1.4.7.1.1.3.2.1.6]
b. 27 Aug 1820 d. 4 Nov 1899
9
Harriet Warner Andrus
[1.4.7.1.1.3.2.1.7]
b. 26 Sep 1824 d. 17 Mar 1890
9
Annie Marie Andrus
[1.4.7.1.1.3.2.1.8]
b. 25 Oct 1827 d. 14 Feb 1881
+
George Franklin Seaver
b. 1 Aug 1840 d. 21 Oct 1861
9
Caroline Adelia Andrus
[1.4.7.1.1.3.2.1.9]
b. 6 Feb 1830 d. 18 Aug 1904
8
Warren Pearson
[1.4.7.1.1.3.2.2]
b. 23 Jul 1792
8
Loren Pearson
[1.4.7.1.1.3.2.3]
b. 5 Oct 1797 d. 19 Jul 1861
7
Zelotes Pearson
[1.4.7.1.1.3.3]
b. 9 Sep 1771
+
Anna
b. Abt 1771
7
Clarice Pearson
[1.4.7.1.1.3.4]
b. 11 Feb 1774
+
John Little
b. Abt 1774
7
Jerusha Pearson
[1.4.7.1.1.3.5]
b. 15 Aug 1776 d. 9 Feb 1874
+
Gates Willey
b. Abt 1776
7
Anna Pearson
[1.4.7.1.1.3.6]
b. 2 Feb 1779 d. 26 Jan 1830
Elam Wright
b. 1 Dec 1774 d. 6 Feb 1831
8
Elam G Wright
[1.4.7.1.1.3.6.1]
b. 10 Feb 1811
8
Alvira Lucretia Wright
[1.4.7.1.1.3.6.2]
b. 17 Aug 1815
8
Vienna Wright
[1.4.7.1.1.3.6.3]
b. 28 Oct 1817 d. 29 Nov 1909
5
Jerusha Taylor
[1.4.7.1.2]
b. 15 Mar 1713
5
Abigail Taylor
[1.4.7.1.3]
b. 10 Feb 1721
5
Margaret Taylor
[1.4.7.1.4]
b. Oct 1725
5
Keziah Taylor
[1.4.7.1.5]
b. 23 Oct 1726 d. 8 Apr 1784
4
John Stiles
[1.4.7.2]
b. 17 Dec 1692 d. 20 Jul 1763
Mary Osborn
b. 10 Feb 1695
5
John Stiles
[1.4.7.2.1]
b. 12 May 1714
5
Isreal Stiles
[1.4.7.2.2]
b. Abt 1716 d. 13 Sep 1794
5
Martha Stiles
[1.4.7.2.3]
b. Feb 1717
5
Benoni Stiles
[1.4.7.2.4]
b. Abt 1723 d. 1760
5
Elizabeth Stiles
[1.4.7.2.5]
b. Abt 1728 d. 11 Nov 1810
5
Ann Stiles
[1.4.7.2.6]
b. Abt 1730
4
Isaac Stiles
[1.4.7.3]
b. 30 Jul 1697 d. 14 May 1760
Keziah Taylor
b. 4 Apr 1702 d. 15 Dec 1727
5
Ezra Stiles
[1.4.7.3.1]
b. 29 Dec 1727
Ester Hooker
b. Abt 1695 d. 2 Jan 1779
5
Isaac Stiles
[1.4.7.3.2]
b. 6 Sep 1729 d. 13 Mar 1783
5
Thankful Stiles
[1.4.7.3.3]
b. 6 Aug 1731 d. 16 Oct 1768
5
Ashabel Stiles
[1.4.7.3.4]
b. Abt 1732 d. 1810
5
Esther Stiles
[1.4.7.3.5]
b. 1 Dec 1733 d. 8 Aug 1737
5
Ashbel Stiles
[1.4.7.3.6]
b. 30 Aug 1734 d. 14 Nov 1810
5
Job Stiles
[1.4.7.3.7]
b. 1 Jul 1738 d. 5 Oct 1738
5
Esther Stiles
[1.4.7.3.8]
b. 8 Aug 1739
5
Job Stiles
[1.4.7.3.9]
b. 4 Nov 1741 d. 15 Aug 1751
5
Ruth Stiles
[1.4.7.3.10]
b. 13 Jun 1744 d. 31 Aug 1759
5
Lucy Stiles
[1.4.7.3.11]
b. 20 Apr 1746 d. 15 Aug 1751
4
Son Stiles
[1.4.7.4]
b. Abt 1698
4
Daughter Stiles
[1.4.7.5]
b. Abt 1698
4
Son Stiles
[1.4.7.6]
b. 1699
4
Ebenezer Stiles
[1.4.7.7]
b. 7 Apr 1701 d. 21 May 1779
Sarah Pinney
b. 1707 d. 14 Aug 1776
5
Sarah Stiles
[1.4.7.7.1]
b. Abt 1732
5
Ann Stiles
[1.4.7.7.2]
b. 20 Jul 1733
5
Ruth Stiles
[1.4.7.7.3]
b. 22 Jan 1734
5
Hannah J Stiles
[1.4.7.7.4]
b. 1739 d. 3 Jan 1815
5
Stephen Stiles
[1.4.7.7.5]
b. 18 Aug 1743 d. 1759
4
Noah Stiles
[1.4.7.8]
b. 31 Jan 1702
Abigail Gaines
b. 27 Apr 1703
5
Noah Stiles, Jr
[1.4.7.8.1]
b. 8 Mar 1735 d. 19 Sep 1807
5
Stiles
[1.4.7.8.2]
b. Abt 1740
4
Abel Stiles
[1.4.7.9]
b. Abt 1704 d. 1704
4
Hannah Stiles
[1.4.7.10]
b. Abt 1706 d. 1710
4
Child Stiles
[1.4.7.11]
b. Abt 1706 d. 1706
4
Benoni Stiles
[1.4.7.12]
b. 1714 d. 1714
3
Samuel Bancraft
[1.4.8]
b. 7 Jan 1677 d. 23 Sep 1746
3
Nathaniel Bancroft
[1.4.9]
b. 24 Oct 1683 d. 10 Feb 1724