Home Page
|
What's New
|
Photos
|
Histories
|
Headstones
|
Reports
|
Surnames
Search
First Name:
Last Name:
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Suomalainen
Svenska
Helen Warren
Abt 1527 - 1597 (70 years)
Submit Photo / Document
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Submit Photo / Doc
Worksheet
Family
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Helen Warren
[1]
b. Abt 1527 d. 1597
John Robert Foote
b. 1523 d. 18 Jul 1558
2
Nathaniel Foote
[1.1]
b. 1550
2
John Foote
[1.2]
b. Abt 1555 d. 17 Nov 1616
2
Aves Foote
[1.3]
b. 1557
2
Elizabeth Foote
[1.4]
b. 18 Jul 1558 d. Aft 1616
2
Richard Foote
[1.5]
b. Abt 1553 d. 13 Feb 1608
Joane Brooke
b. 18 Jun 1559 d. 10 Oct 1634
3
Robert Foote
[1.5.1]
b. 1578 bur. 17 Aug 1646
3
Frances Foote
[1.5.2]
b. 1582 d. 13 Jan 1683
3
Mary Foote
[1.5.3]
b. 1584 d. 10 Oct 1634
3
James Foote
[1.5.4]
b. 1586 d. 1649
3
Elizabeth Foote
[1.5.5]
b. Abt 1587
3
Nathaniel Foote
[1.5.6]
b. 21 Sep 1592 d. 28 Jul 1644
Elizabeth Deming
b. Oct 1595 d. 28 Jul 1683
4
Nathaniel Foote
[1.5.6.1]
b. 5 Mar 1619 d. Jun 1655
4
Joanna Foote
[1.5.6.2]
b. 10 Mar 1625 d. 14 Sep 1666
Lieutenant Joseph Kellogg
b. 1 Apr 1626 d. 4 Feb 1708
5
Nathaniel Kellogg
[1.5.6.2.1]
b. 29 Oct 1654 d. 30 Oct 1750
Sarah Boltwood
b. 1 Oct 1672 d. 26 Jan 1761
6
Nathaniel Kellogg
[1.5.6.2.1.1]
b. 22 Sep 1693 d. 6 Aug 1770
Sarah Preston
b. 8 Nov 1693 d. 15 Sep 1756
7
Daniel Kellogg
[1.5.6.2.1.1.1]
b. 1717 d. 14 Jan 1799
7
Abraham Kellogg
[1.5.6.2.1.1.2]
b. 1719 bur. 1776
7
Gardener Kellogg
[1.5.6.2.1.1.3]
b. 1723 d. 6 Oct 1814
7
Prudence Kellogg
[1.5.6.2.1.1.4]
b. 1723 d. 27 Jun 1791
7
Joel Kellogg
[1.5.6.2.1.1.5]
b. Abt 1728 d. 22 Oct 1798
Joanna Clark
b. 10 May 1695 d. 11 Jun 1795
8
Miriam Kellogg
[1.5.6.2.1.1.5.1]
b. 22 Dec 1751 d. 2 Feb 1824
8
Seth Kellogg
[1.5.6.2.1.1.5.2]
b. 1754 d. 30 Nov 1827
Jerusha White
b. 5 Mar 1762
9
Joel Kellogg
[1.5.6.2.1.1.5.2.1]
b. 24 Jan 1782 d. 24 Jan 1845
9
Oliver White Kellogg
[1.5.6.2.1.1.5.2.2]
b. Abt 1783 d. 24 Jan 1845
9
Jerusha Rebecca Kellogg
[1.5.6.2.1.1.5.2.3]
b. 15 Nov 1785 d. 23 Aug 1836
Charles Robison, Jr
b. 5 Jun 1785 d. 4 Oct 1840
10
Chauncey Robison
[1.5.6.2.1.1.5.2.3.1]
b. 27 Mar 1805 d. 4 Nov 1891
10
Malinda Robison
[1.5.6.2.1.1.5.2.3.2]
b. 11 Nov 1806 d. 16 May 1898
10
John Knapp Robison
[1.5.6.2.1.1.5.2.3.3]
b. 2 Oct 1808 d. 27 Jan 1887
10
James Robison
[1.5.6.2.1.1.5.2.3.4]
b. 11 Sep 1810 d. 20 Apr 1841
10
William Robison
[1.5.6.2.1.1.5.2.3.5]
b. 4 Oct 1812 d. 10 Oct 1812
10
Lucinda Robison
[1.5.6.2.1.1.5.2.3.6]
b. 20 Jul 1814 d. 14 May 1893
10
Lewis Robison
[1.5.6.2.1.1.5.2.3.7]
b. 28 Oct 1816 d. 1 Nov 1883
Clarissa Minerva Duzette
b. 18 Dec 1822 d. 21 Oct 1891
11
James Madison Robison
[1.5.6.2.1.1.5.2.3.7.1]
b. 8 Aug 1841 d. 14 Jun 1842
11
Solon Wells Robison
[1.5.6.2.1.1.5.2.3.7.2]
b. 10 Apr 1843 d. 12 Dec 1925
11
Charles Edward Robison
[1.5.6.2.1.1.5.2.3.7.3]
b. 2 Dec 1845 d. 26 Sep 1883
Mary Louisa Fretwell
b. 1 Sep 1853 d. 29 Aug 1882
12
Michael Chancy Fretwell Paine
[1.5.6.2.1.1.5.2.3.7.3.1]
b. 10 Mar 1873 d. Aug 1874
12
William Zebulon Fretwell Paine
[1.5.6.2.1.1.5.2.3.7.3.2]
b. 19 Nov 1877 d. Mar 1878
12
Joseph Fretwell Paine
[1.5.6.2.1.1.5.2.3.7.3.3]
b. 12 Aug 1882 d. 31 Aug 1882
Rosetta Mary Berry
b. 3 Jul 1843 d. 21 Oct 1918
12
Clarissa Elnora Robison
[1.5.6.2.1.1.5.2.3.7.3.4]
b. 29 Sep 1866 d. 19 Apr 1948
12
Charles Albert Robison
[1.5.6.2.1.1.5.2.3.7.3.5]
b. 5 Aug 1868 d. 11 May 1945
12
Robert Lewis Robison
[1.5.6.2.1.1.5.2.3.7.3.6]
b. 17 Jul 1873 d. 2 Sep 1944
12
Rosetta Lenore Robison
[1.5.6.2.1.1.5.2.3.7.3.7]
b. 12 Feb 1877 d. 10 May 1919
12
Alma Luella Robison
[1.5.6.2.1.1.5.2.3.7.3.8]
b. 19 Aug 1882 d. 8 Sep 1938 [
=>
]
11
Lewis Duzette Robison
[1.5.6.2.1.1.5.2.3.7.4]
b. 13 Jun 1848 d. 8 May 1879
11
John Albert Robison
[1.5.6.2.1.1.5.2.3.7.5]
b. 29 Jul 1850 d. 29 Oct 1935
11
Clarissa Eliza Robison
[1.5.6.2.1.1.5.2.3.7.6]
b. 30 Mar 1854 d. 3 Jun 1937
11
Maria Mary Robison
[1.5.6.2.1.1.5.2.3.7.7]
b. 15 Oct 1855 d. 26 Jul 1911
11
Annie Louise Robison
[1.5.6.2.1.1.5.2.3.7.8]
b. 30 Oct 1857 d. 27 Feb 1939
11
Joseph Smith Robison
[1.5.6.2.1.1.5.2.3.7.9]
b. 10 Jan 1860 d. 10 Jan 1944
11
Irene Elizabeth Robison
[1.5.6.2.1.1.5.2.3.7.10]
b. 16 Jun 1862 d. 26 Nov 1946
Mary Jane Waite
b. 12 Jan 1836 d. 18 Mar 1922
11
Seth Milton Robison
[1.5.6.2.1.1.5.2.3.7.11]
b. 11 May 1857 d. 31 Dec 1896
11
Minerva Rebecca Robison
[1.5.6.2.1.1.5.2.3.7.12]
b. 19 Jul 1860 d. 23 Dec 1862
11
Emma Lenora Robison
[1.5.6.2.1.1.5.2.3.7.13]
b. 11 Oct 1862 d. 9 Aug 1906
11
Daniel Hanmer Robison
[1.5.6.2.1.1.5.2.3.7.14]
b. 28 Apr 1865 d. 27 Dec 1924
11
Inez Melissa Robison
[1.5.6.2.1.1.5.2.3.7.15]
b. 30 May 1868 d. 11 Feb 1945
11
Guy Kellogg Robison
[1.5.6.2.1.1.5.2.3.7.16]
b. 3 Apr 1871 d. 6 Sep 1948
+
Achsah Melissa Allred
b. 6 Oct 1824 d. 28 Sep 1901
Louisa R Gheen
b. 28 May 1843 d. 15 Oct 1932
11
Ellen Aseneth Robison
[1.5.6.2.1.1.5.2.3.7.17]
b. 18 Oct 1860 d. 16 Apr 1861
11
William Gheen Robison
[1.5.6.2.1.1.5.2.3.7.18]
b. 4 Apr 1865 d. 7 Oct 1865
11
May Jerusha Robison
[1.5.6.2.1.1.5.2.3.7.19]
b. 25 Jan 1867 d. 21 Sep 1956
11
Lydia Manette Robison
[1.5.6.2.1.1.5.2.3.7.20]
b. 9 Jun 1868 d. 20 Oct 1953
11
Nellie Isola Robison
[1.5.6.2.1.1.5.2.3.7.21]
b. 24 Nov 1871 d. 19 Apr 1949
11
Rose Drucilla Robison
[1.5.6.2.1.1.5.2.3.7.22]
b. 25 Oct 1873 d. 22 Apr 1921
11
Georgia Louisa Robison
[1.5.6.2.1.1.5.2.3.7.23]
b. Oct 1875 d. 1 Mar 1877
10
Sarah Maria Robison
[1.5.6.2.1.1.5.2.3.8]
b. 10 Jan 1819 d. 24 Jul 1906
10
Eliza Rebecca Robison
[1.5.6.2.1.1.5.2.3.9]
b. 4 Jan 1820 d. 2 Aug 1905
10
Julia Ann Robison
[1.5.6.2.1.1.5.2.3.10]
b. 14 Feb 1822 d. 30 Jan 1912
10
Charles Robison
[1.5.6.2.1.1.5.2.3.11]
b. 15 Feb 1824 d. 29 Dec 1888
10
Seth Kellogg Robison
[1.5.6.2.1.1.5.2.3.12]
b. 7 Dec 1827 d. 14 Feb 1910
9
Orange Kellogg
[1.5.6.2.1.1.5.2.4]
b. Abt 1787 d. 2 Apr 1852
9
Samuel Kellogg
[1.5.6.2.1.1.5.2.5]
b. Abt 1791 d. 1842
9
Elijah Walley Kellogg
[1.5.6.2.1.1.5.2.6]
b. 26 Oct 1792 d. 21 Nov 1835
9
Lucinda Kellogg
[1.5.6.2.1.1.5.2.7]
b. 1795
9
Clarissa Kellogg
[1.5.6.2.1.1.5.2.8]
b. 1797 d. Abt 1815
9
Joseph Kellogg
[1.5.6.2.1.1.5.2.9]
b. 26 Oct 1799 d. 9 May 1876
9
Levi Kellogg
[1.5.6.2.1.1.5.2.10]
b. 1801
9
David Kellogg
[1.5.6.2.1.1.5.2.11]
b. Abt 1803
9
Lucretia Kellogg
[1.5.6.2.1.1.5.2.12]
b. 1805
8
Joanna Kellogg
[1.5.6.2.1.1.5.3]
b. Abt 1755 d. 28 May 1816
8
Abigail Kellogg
[1.5.6.2.1.1.5.4]
b. 18 Nov 1757 d. 8 Jan 1833
8
Levi Kellogg
[1.5.6.2.1.1.5.5]
b. 3 Oct 1760 d. 3 Jan 1848
7
Moses Kellogg
[1.5.6.2.1.1.6]
b. 1733 d. 28 May 1815
7
Phoebe Kellogg
[1.5.6.2.1.1.7]
b. 9 Nov 1734 d. Abt 1777
6
Ebenezer Kellogg
[1.5.6.2.1.2]
b. 31 May 1695 d. 17 Aug 1766
6
Ezekiel Kellogg
[1.5.6.2.1.3]
b. 15 Apr 1697 d. Abt 1753
6
Sarah Kellogg
[1.5.6.2.1.4]
b. 12 Mar 1701 d. 22 Mar 1743
6
Abigail Kellogg
[1.5.6.2.1.5]
b. 19 Mar 1703 d. 10 Sep 1756
6
Mary Kellogg
[1.5.6.2.1.6]
b. 9 Mar 1706 d. 29 Dec 1788
6
Ephraim Kellogg
[1.5.6.2.1.7]
b. 2 Aug 1709 d. 16 Mar 1777
6
Experience Kellogg
[1.5.6.2.1.8]
b. 1711
5
Samuel Kellogg
[1.5.6.2.2]
b. 28 Sep 1662 d. 1717
5
Joanna Kellogg
[1.5.6.2.3]
b. 8 Dec 1664 d. 16 Apr 1727
4
Robert Foote
[1.5.6.3]
b. 8 Dec 1627 d. 1681
4
Frances Foote
[1.5.6.4]
b. 1629 d. 3 Feb 1678
4
Sarah Foote
[1.5.6.5]
b. 12 Feb 1631 d. 26 Mar 1704
Josiah Judson
b. 1622
5
Isaac Judson
[1.5.6.5.1]
b. 10 Mar 1653 d. 1687
5
Mary Judson
[1.5.6.5.2]
b. 31 Dec 1655
5
Elizabeth Judson
[1.5.6.5.3]
b. 24 Feb 1657 d. Abt 1691
5
Sarah Judson
[1.5.6.5.4]
b. 7 Apr 1662
5
Mercy Judson
[1.5.6.5.5]
b. 14 Jun 1665 d. Abt 1736
5
Jeremiah Judson
[1.5.6.5.6]
b. 1 Mar 1670 d. 9 Feb 1734
Mary Welles
b. 29 Nov 1670 d. Bef 11 Oct 1751
6
Eunice Judson
[1.5.6.5.6.1]
b. 1695
Nathaniel Curtis
b. 21 Feb 1690
7
Jeremia Judson Curtis
[1.5.6.5.6.1.1]
b. 4 Apr 1716 d. 4 Sep 1782
7
Mary Curtis
[1.5.6.5.6.1.2]
b. 28 Aug 1717 d. 18 Dec 1781
Nathaniel Curtis
b. Abt 1716 d. 1791
8
Abigail Curtis
[1.5.6.5.6.1.2.1]
b. 17 Mar 1742 d. May 1820
Samuel Tiffany
b. 13 Jul 1740 d. Mar 1822
9
Samuel Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.1]
b. 21 Oct 1761 d. 21 Apr 1851
Mary Sackett
b. Abt 1761 d. 1862
10
Samuel Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.1.1]
b. 1788 d. Abt 1845
10
Mary Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.1.2]
b. 1797
10
Julia Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.1.3]
b. 1799 d. 13 Jan 1891
10
Thomas Jefferson Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.1.4]
b. 1801
10
Hannah Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.1.5]
b. 5 Apr 1804 d. 10 Sep 1860
10
Calinda Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.1.6]
b. 2 Dec 1807 d. 5 Mar 1866
10
Ezekiel Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.1.7]
b. 1810
10
Jefferson Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.1.8]
b. Abt 1810
10
Harry Edward Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.1.9]
b. 25 Jun 1813 d. 14 Dec 1871
10
Harriet Emeline Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.1.10]
b. Abt 1815
10
Lorenzo Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.1.11]
b. Abt 1818
9
Nathanial Curtis Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.2]
b. 18 Feb 1762 d. 13 Feb 1857
Dency Crane
b. Abt 1765
10
Nathaniel Curtis Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.2.1]
b. Mar 1790
10
Harriet Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.2.2]
b. Mar 1792 d. 1858
10
Dancy Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.2.3]
b. 25 Sep 1795 d. 24 Mar 1846
10
Anron Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.2.4]
b. 2 Jun 1797 d. 27 Feb 1847
10
Betsey Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.2.5]
b. Abt 1799
10
David Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.2.6]
b. 1800
10
Mary Polly Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.2.7]
b. 17 Dec 1801 d. 20 May 1835
10
Elizabeth Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.2.8]
b. 1805
10
Caroline Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.2.9]
b. Abt 1807 d. 1843
9
Jemima Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.3]
b. 1763 d. 6 Mar 1848
Reuben Ward
b. 13 Nov 1748 d. 5 Jul 1825
10
Affa Ward
[1.5.6.5.6.1.2.1.3.1]
b. 27 May 1783 d. 28 Feb 1877
William Stilson
b. 23 Sep 1783 d. 4 May 1862
11
Caroline Stilson
[1.5.6.5.6.1.2.1.3.1.1]
b. 20 Jan 1808 d. 12 Jan 1883
11
Albert Stilson
[1.5.6.5.6.1.2.1.3.1.2]
b. 16 Jan 1810 d. 30 Sep 1895
11
Celinda Stilson
[1.5.6.5.6.1.2.1.3.1.3]
b. 4 Feb 1811 d. 26 Jun 1845
11
Emeline Stilson
[1.5.6.5.6.1.2.1.3.1.4]
b. 27 Sep 1813 d. 6 Jan 1887
11
William M Stilson
[1.5.6.5.6.1.2.1.3.1.5]
b. 2 Apr 1816
11
Saphronia Stilson
[1.5.6.5.6.1.2.1.3.1.6]
b. 3 Nov 1817 d. 6 Jan 1887
11
Minor Stilson
[1.5.6.5.6.1.2.1.3.1.7]
b. 9 Jan 1821
11
Affa C Stilson
[1.5.6.5.6.1.2.1.3.1.8]
b. 31 Mar 1823 d. Abt 1879
11
Rueben R Stilson
[1.5.6.5.6.1.2.1.3.1.9]
b. 29 Dec 1824
11
Allen Stilson
[1.5.6.5.6.1.2.1.3.1.10]
b. 12 Apr 1827 d. 25 Jan 1878
10
Reuben Ward
[1.5.6.5.6.1.2.1.3.2]
b. Abt 1784 d. 5 Mar 1876
10
Jemima Ward
[1.5.6.5.6.1.2.1.3.3]
b. Abt 1786
10
Laura Ward
[1.5.6.5.6.1.2.1.3.4]
b. Abt 1790
10
Eda Ward
[1.5.6.5.6.1.2.1.3.5]
b. Abt 1788
10
Samuel Ward
[1.5.6.5.6.1.2.1.3.6]
b. Abt 1792 d. 23 Feb 1873
10
Dorcas Ward
[1.5.6.5.6.1.2.1.3.7]
b. Abt 1794
10
Cynthia Ward
[1.5.6.5.6.1.2.1.3.8]
b. Abt 1796
+
Henry Rolluff
b. Abt 1782
10
William B Ward
[1.5.6.5.6.1.2.1.3.9]
b. 1801
10
Daniel Ward
[1.5.6.5.6.1.2.1.3.10]
b. 1807
9
William Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.4]
b. Abt 1765
9
Emellason Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.5]
b. Abt 1765 d. 18 Mar 1847
Sarah Aldrich
b. 4 Apr 1773
10
Rhoda Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.5.1]
b. 1 Nov 1793
10
George Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.5.2]
b. 5 May 1794
10
Lemuel Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.5.3]
b. 30 Jun 1796
10
David Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.5.4]
b. 18 Aug 1798
10
Sarah Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.5.5]
b. 27 Mar 1803 d. 14 Nov 1838
10
Silas Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.5.6]
b. 13 Apr 1809
9
Daniel Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.6]
b. 18 Sep 1768 d. 25 Sep 1793
+
Phebe Rand
b. Abt 1770
9
Abigail Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.7]
b. Abt 1770
+
Zenos Aldrich
b. 1766 d. 8 Nov 1856
9
George Obediah Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.8]
b. 7 May 1772 d. 13 Feb 1857
Mary Mason
b. Abt 1766 d. 16 Mar 1840
10
Abigail Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.1]
b. Abt 1797 d. Dec 1859
10
Zilpha Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.2]
b. Abt 1799 d. 1830
10
Zenas Schovil Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.3]
b. 25 Jun 1801 d. 1822
10
Luther Little Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.4]
b. 28 Mar 1803 d. 17 Feb 1881
10
Frederick Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.5]
b. 1804 d. 1804
10
Lorenzo Mason Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.6]
b. Abt 1804 d. Abt 1809
10
Jane Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.7]
b. 14 Apr 1805 d. 26 Nov 1867
10
George Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.8]
b. 4 May 1808 d. 21 Jun 1885
Almira Whipple
b. 13 Jun 1810 d. 4 Feb 1889
11
Cynthia Jane Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.8.1]
b. 2 Feb 1830 d. 6 Oct 1845
11
Zenos Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.8.2]
b. 21 Jul 1831 d. Dec 1843
11
Ira Patchen Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.8.3]
b. 14 Feb 1835 d. 21 Mar 1905
Mary Ann Davis
b. 4 Oct 1843 d. 21 Jul 1885
12
Ira Davies Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.8.3.1]
b. 24 Jul 1863 d. 27 Oct 1902
12
Zenos William Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.8.3.2]
b. 21 Aug 1865 d. 14 Feb 1938
12
Sylvia Ann Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.8.3.3]
b. 14 Nov 1867 d. 23 Dec 1936
12
Cynthia Jane Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.8.3.4]
b. 27 Feb 1870 d. Bef 1877
12
Mary Elizabeth Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.8.3.5]
b. 17 May 1871 d. 5 Nov 1887
12
Almira Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.8.3.6]
b. 29 Dec 1873 d. 21 Sep 1887
12
Franklin Brayn Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.8.3.7]
b. 29 Feb 1876 d. 4 Oct 1877
12
Eliza Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.8.3.8]
b. 30 Jan 1878 d. 2 Jun 1957
12
George Hyrum Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.8.3.9]
b. 17 Apr 1880 d. 18 Mar 1939
12
Albert Henry Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.8.3.10]
b. 5 Nov 1882 d. 2 Dec 1956
12
Ray Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.8.3.11]
b. 21 Jul 1884 d. 16 Oct 1885
+
Sarah Ann Jolley
b. 18 Dec 1837 d. 9 Jan 1919
11
Loyal Peck Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.8.4]
b. 27 Jul 1837 d. 15 Feb 1903
+
Martha Holden
b. 28 Jan 1825 d. 3 May 1886
11
Mary Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.8.5]
b. 18 Dec 1844 d. 14 Dec 1845
11
Almira Rebecca Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.8.6]
b. 18 Aug 1847 d. 23 Nov 1914
Giles Bliss Holden
b. 8 May 1842 d. 20 May 1897
12
Almira Rebecca Holden
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.8.6.1]
b. 8 Aug 1865 d. 25 Aug 1865
12
Ruia Angeline Holden
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.8.6.2]
b. 21 Oct 1866 d. 4 Mar 1948
12
Giles Robert Holden
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.8.6.3]
b. 8 Dec 1868 d. Mar 1889
12
Cynthia Holden
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.8.6.4]
b. 10 Mar 1870 d. 10 Mar 1870
12
George Tiffany Holden
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.8.6.5]
b. 9 May 1872 d. 13 Apr 1934
12
Nellie May Holden
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.8.6.6]
b. 30 Dec 1875 d. 6 Nov 1935
12
Burrell Henry Holden
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.8.6.7]
b. 29 Jun 1877 d. 11 Mar 1881
12
Leroy Edwin Holden
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.8.6.8]
b. 21 Sep 1879 d. 12 Feb 1881
12
Ivy LeNore Holden
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.8.6.9]
b. 24 May 1882 d. 18 Aug 1958
12
Merle Dee Holden
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.8.6.10]
b. 10 Jul 1885 d. 12 Sep 1938
12
Verna Holden
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.8.6.11]
b. 18 Dec 1887 d. 18 Dec 1887
12
Vera Holden
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.8.6.12]
b. 18 Dec 1887 d. 12 Feb 1967 [
=>
]
11
George Mason Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.8.7]
b. 31 Jan 1850 d. 14 Mar 1909
Sarah Jane York
b. 18 Feb 1857 d. 27 Dec 1940
12
Mary Ellen Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.8.7.1]
b. 22 Aug 1874 d. 18 Jun 1958
12
Sarah Jane Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.8.7.2]
b. 16 Apr 1876 d. 23 Apr 1883
12
George Mason Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.8.7.3]
b. 17 Nov 1877 d. 21 Apr 1883
12
Asa York Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.8.7.4]
b. 24 Feb 1881 d. 3 Feb 1947
12
Lea Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.8.7.5]
b. 7 May 1883 d. 7 Jan 1961
12
Ira George Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.8.7.6]
b. 7 May 1883 d. 7 Jan 1961
12
Nelson Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.8.7.7]
b. 4 Aug 1885 d. 27 Mar 1943
12
Almira Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.8.7.8]
b. 16 Sep 1888 d. 26 Jul 1966
12
Ruia Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.8.7.9]
b. 27 Nov 1890 d. 15 May 1965
12
Lenore Henrietta Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.8.7.10]
b. 9 Aug 1893 d. 11 Sep 1967
11
Nelson Whipple Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.8.8]
b. 6 Aug 1852 d. 20 Jan 1927
Nancy Medora Beesley
b. 8 Sep 1862 d. 15 May 1924
12
Nelson Whipple Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.8.8.1]
b. 11 Sep 1880 d. 20 Nov 1904
12
Florence Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.8.8.2]
b. 27 Apr 1882 d. 22 May 1964
12
Alathea Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.8.8.3]
b. 28 Aug 1884 d. 3 Jan 1897
12
Ida May Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.8.8.4]
b. 15 Nov 1888 d. 9 May 1968
12
George Milton Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.8.8.5]
b. 8 May 1892 d. 25 May 1963
12
Martha Elva Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.8.8.6]
b. 1 Aug 1898 d. 25 Nov 1989
12
Viola Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.8.8.7]
b. 5 Jul 1903 d. 19 Jun 1969
10
Lorenzo Roderick Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.9]
b. 4 Jul 1810 d. Abt 1810
10
Richard Mason Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.10]
b. 4 Jul 1810 d. 1897
10
Daniel Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.11]
b. 12 Sep 1812 d. 25 Jan 1894
10
Mary Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.12]
b. 28 Mar 1814 d. 1899
10
Phebe Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.13]
b. 24 Oct 1817 d. 20 Feb 1850
10
Larena Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.14]
b. 1818 d. 1844
10
Ann Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.8.15]
b. 4 Jun 1822 d. 12 Sep 1893
9
Mary Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.9]
b. 17 Jun 1777 d. 12 Sep 1845
Daniel Whipple
b. 27 Aug 1779 d. 27 Sep 1839
10
Cynthia Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.1]
b. 15 Jan 1805 d. 1889
Ezra Gray
b. 1793 d. 1870
11
Hiram T Gray
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.1.1]
b. 25 Aug 1832 d. 30 Jun 1875
+
Caroline R Lane
b. 1839 d. 1902
11
Daniel William Gray
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.1.2]
b. 19 May 1834 d. 9 Dec 1890
Eliza Jane Ostrander
b. Abt 1840 d. 29 Oct 1861
12
William Delvin Grey
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.1.2.1]
b. 27 Feb 1859 d. 11 Aug 1949
12
Frank Gray
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.1.2.2]
b. Abt 1861
Sarah Ann Smith
b. 19 Dec 1851 d. 15 Jan 1941
12
Jennie Gray
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.1.2.3]
b. 3 May 1870 d. 5 Oct 1941
12
Nellie F Gray
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.1.2.4]
b. 2 Jul 1871 d. Aug 1883
12
Frank N Gray
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.1.2.5]
b. 3 Nov 1873
12
Mary Ellen Gray
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.1.2.6]
b. 27 Aug 1877 d. 23 Feb 1953
12
Carrie M Gray
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.1.2.7]
b. 8 Dec 1881 d. 12 Sep 1949
11
Daughter Gray
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.1.3]
b. 1834
11
Emily Jane Gray
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.1.4]
b. 14 Nov 1837 d. 13 Feb 1908
11
Betsey T Gray
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.1.5]
b. 1840
11
Mary M Gray
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.1.6]
b. 1844
11
George W Gray
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.1.7]
b. 1846 d. 4 Aug 1918
Sidney
b. Jan 1846
12
Ramond G Gray
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.1.7.1]
b. Apr 1869
12
Minnie M Gray
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.1.7.2]
b. May 1872 [
=>
]
12
Floyd Gray
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.1.7.3]
b. Sep 1874
12
Daisey M Gray
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.1.7.4]
b. Jun 1881
10
Samuel Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.2]
b. 21 Dec 1808 d. 9 Jan 1887
Phoebe Kingsbury
b. 14 Dec 1812 d. 24 Apr 1851
11
Sabrina Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.2.1]
b. 30 Mar 1832 d. 1920
+
Scudder Todd
b. 1831 d. 1901
11
George T Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.2.2]
b. 4 Dec 1833 d. 28 Aug 1868
11
Polly Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.2.3]
b. 4 Jun 1835 d. 24 Mar 1855
11
Daniel Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.2.4]
b. 21 Jun 1837
11
Margaret Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.2.5]
b. 18 Jun 1839 d. 8 Oct 1840
11
Mason Kingsbury Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.2.6]
b. 17 Feb 1842 d. 27 Mar 1919
Olive Amanda Kingsbury
b. 10 Dec 1844 d. 1924
12
Nelson E Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.2.6.1]
b. 1867 d. 1943
12
Ina Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.2.6.2]
b. Sep 1869
12
George W Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.2.6.3]
b. Jan 1872
12
Pearl O Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.2.6.4]
b. Jun 1884
11
Samuel Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.2.7]
b. 4 Mar 1844 d. May 1924
11
Hassett Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.2.8]
b. 20 Feb 1846 d. 3 Jan 1852
11
Almira Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.2.9]
b. 21 Apr 1848 d. 22 Sep 1911
+
Franklin F King
b. 1845 d. 1898
11
Cynthia Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.2.10]
b. 10 Nov 1850 d. 17 Apr 1851
10
Almira Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.3]
b. 13 Jun 1810 d. 4 Feb 1889
George Tiffany
b. 4 May 1808 d. 21 Jun 1885
11
Cynthia Jane Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.3.1]
b. 2 Feb 1830 d. 6 Oct 1845
11
Zenos Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.3.2]
b. 21 Jul 1831 d. Dec 1843
11
Ira Patchen Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.3.3]
b. 14 Feb 1835 d. 21 Mar 1905
Mary Ann Davis
b. 4 Oct 1843 d. 21 Jul 1885
12
Ira Davies Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.3.3.1]
b. 24 Jul 1863 d. 27 Oct 1902
12
Zenos William Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.3.3.2]
b. 21 Aug 1865 d. 14 Feb 1938
12
Sylvia Ann Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.3.3.3]
b. 14 Nov 1867 d. 23 Dec 1936
12
Cynthia Jane Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.3.3.4]
b. 27 Feb 1870 d. Bef 1877
12
Mary Elizabeth Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.3.3.5]
b. 17 May 1871 d. 5 Nov 1887
12
Almira Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.3.3.6]
b. 29 Dec 1873 d. 21 Sep 1887
12
Franklin Brayn Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.3.3.7]
b. 29 Feb 1876 d. 4 Oct 1877
12
Eliza Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.3.3.8]
b. 30 Jan 1878 d. 2 Jun 1957
12
George Hyrum Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.3.3.9]
b. 17 Apr 1880 d. 18 Mar 1939
12
Albert Henry Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.3.3.10]
b. 5 Nov 1882 d. 2 Dec 1956
12
Ray Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.3.3.11]
b. 21 Jul 1884 d. 16 Oct 1885
+
Sarah Ann Jolley
b. 18 Dec 1837 d. 9 Jan 1919
11
Loyal Peck Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.3.4]
b. 27 Jul 1837 d. 15 Feb 1903
+
Martha Holden
b. 28 Jan 1825 d. 3 May 1886
11
Mary Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.3.5]
b. 18 Dec 1844 d. 14 Dec 1845
11
Almira Rebecca Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.3.6]
b. 18 Aug 1847 d. 23 Nov 1914
Giles Bliss Holden
b. 8 May 1842 d. 20 May 1897
12
Almira Rebecca Holden
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.3.6.1]
b. 8 Aug 1865 d. 25 Aug 1865
12
Ruia Angeline Holden
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.3.6.2]
b. 21 Oct 1866 d. 4 Mar 1948
12
Giles Robert Holden
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.3.6.3]
b. 8 Dec 1868 d. Mar 1889
12
Cynthia Holden
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.3.6.4]
b. 10 Mar 1870 d. 10 Mar 1870
12
George Tiffany Holden
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.3.6.5]
b. 9 May 1872 d. 13 Apr 1934
12
Nellie May Holden
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.3.6.6]
b. 30 Dec 1875 d. 6 Nov 1935
12
Burrell Henry Holden
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.3.6.7]
b. 29 Jun 1877 d. 11 Mar 1881
12
Leroy Edwin Holden
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.3.6.8]
b. 21 Sep 1879 d. 12 Feb 1881
12
Ivy LeNore Holden
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.3.6.9]
b. 24 May 1882 d. 18 Aug 1958
12
Merle Dee Holden
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.3.6.10]
b. 10 Jul 1885 d. 12 Sep 1938
12
Verna Holden
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.3.6.11]
b. 18 Dec 1887 d. 18 Dec 1887
12
Vera Holden
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.3.6.12]
b. 18 Dec 1887 d. 12 Feb 1967 [
=>
]
11
George Mason Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.3.7]
b. 31 Jan 1850 d. 14 Mar 1909
Sarah Jane York
b. 18 Feb 1857 d. 27 Dec 1940
12
Mary Ellen Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.3.7.1]
b. 22 Aug 1874 d. 18 Jun 1958
12
Sarah Jane Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.3.7.2]
b. 16 Apr 1876 d. 23 Apr 1883
12
George Mason Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.3.7.3]
b. 17 Nov 1877 d. 21 Apr 1883
12
Asa York Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.3.7.4]
b. 24 Feb 1881 d. 3 Feb 1947
12
Lea Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.3.7.5]
b. 7 May 1883 d. 7 Jan 1961
12
Ira George Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.3.7.6]
b. 7 May 1883 d. 7 Jan 1961
12
Nelson Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.3.7.7]
b. 4 Aug 1885 d. 27 Mar 1943
12
Almira Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.3.7.8]
b. 16 Sep 1888 d. 26 Jul 1966
12
Ruia Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.3.7.9]
b. 27 Nov 1890 d. 15 May 1965
12
Lenore Henrietta Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.3.7.10]
b. 9 Aug 1893 d. 11 Sep 1967
11
Nelson Whipple Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.3.8]
b. 6 Aug 1852 d. 20 Jan 1927
Nancy Medora Beesley
b. 8 Sep 1862 d. 15 May 1924
12
Nelson Whipple Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.3.8.1]
b. 11 Sep 1880 d. 20 Nov 1904
12
Florence Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.3.8.2]
b. 27 Apr 1882 d. 22 May 1964
12
Alathea Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.3.8.3]
b. 28 Aug 1884 d. 3 Jan 1897
12
Ida May Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.3.8.4]
b. 15 Nov 1888 d. 9 May 1968
12
George Milton Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.3.8.5]
b. 8 May 1892 d. 25 May 1963
12
Martha Elva Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.3.8.6]
b. 1 Aug 1898 d. 25 Nov 1989
12
Viola Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.3.8.7]
b. 5 Jul 1903 d. 19 Jun 1969
10
Phoebe Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.4]
b. 13 Aug 1813 d. 18 Nov 1846
Benjamin Bengraw Shaw
b. 1808
11
Clymenia Azuba Shaw
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.4.1]
b. 2 Feb 1834 d. 10 Aug 1920
David Evans
b. 27 Oct 1804 d. 23 Jun 1883
12
Phebe Jane Evans
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.4.1.1]
b. 1 Dec 1855 d. 18 Dec 1855
12
James Evans
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.4.1.2]
b. 16 Aug 1857 d. 15 Apr 1940 [
=>
]
12
Edwin Thomas Evans
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.4.1.3]
b. 2 Feb 1860 d. 4 Mar 1946 [
=>
]
Benjamin Gibson
b. 9 May 1805 d. 26 Nov 1897
11
Hannah Gibson
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.4.2]
b. 24 Apr 1836 d. 31 Oct 1846
11
Isabella Amy Gibson
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.4.3]
b. 20 Mar 1838 d. 11 Feb 1898
William Coleman
b. 9 Dec 1836 d. 12 Feb 1910
12
William Coleman, Jr
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.4.3.1]
b. 3 Oct 1858 d. 19 Aug 1936 [
=>
]
12
Phebe Jane Coleman
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.4.3.2]
b. 20 May 1860 d. 11 Jun 1936 [
=>
]
12
Benjamin Leo Coleman
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.4.3.3]
b. 2 Sep 1862 d. 23 Jan 1937 [
=>
]
12
Amy Jane Coleman
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.4.3.4]
b. 13 May 1865 d. 19 Oct 1865
12
Mary Elizabeth Coleman
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.4.3.5]
b. 12 Apr 1866 d. 12 Dec 1869
12
John Coleman
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.4.3.6]
b. 6 Nov 1866 d. 24 Jul 1937 [
=>
]
12
Franklin Coleman
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.4.3.7]
b. 18 Mar 1868 d. 1 Jul 1917 [
=>
]
12
Hyrum Coleman
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.4.3.8]
b. 19 Aug 1868 d. 8 Oct 1947 [
=>
]
12
Prime Henry Coleman
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.4.3.9]
b. 24 Apr 1871 d. 30 Mar 1948
12
Sarah Francetta Coleman
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.4.3.10]
b. 20 Jun 1875 d. 9 May 1931 [
=>
]
12
Esther Coleman
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.4.3.11]
b. 8 Dec 1880 d. 1 Mar 1908 [
=>
]
11
Mary Jane Gibson
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.4.4]
b. 5 Feb 1840 d. 12 Jun 1912
Orson Kelsey
b. 1 Oct 1840 d. 7 May 1922
12
Mary Ellen Kelsey
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.4.4.1]
b. 22 Jan 1860 d. 28 Oct 1889 [
=>
]
12
Orson Kelsey, Jr
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.4.4.2]
b. 27 Aug 1861 d. 23 Mar 1904 [
=>
]
12
Benjamin Franklin Kelsey
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.4.4.3]
b. 6 Jun 1865 d. 28 Sep 1937 [
=>
]
12
Orin Kelsey
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.4.4.4]
b. 27 Sep 1866 d. 28 Sep 1866
12
George Albert Kelsey
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.4.4.5]
b. 6 Nov 1868 d. 10 Sep 1946
12
Theodore Kelsey
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.4.4.6]
b. 20 May 1871 d. 2 May 1963 [
=>
]
12
Abigail Kelsey
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.4.4.7]
b. 17 Feb 1873 d. 10 Dec 1956 [
=>
]
12
Easton Lemoine Kelsey
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.4.4.8]
b. 18 Oct 1875 d. 23 Jul 1963 [
=>
]
12
Amos C Kelsey
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.4.4.9]
b. 26 Jul 1876 d. 5 Sep 1956 [
=>
]
12
Rupert Lee Kelsey
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.4.4.10]
b. 8 Dec 1878 d. 12 Aug 1961 [
=>
]
12
Elmira Kelsey
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.4.4.11]
b. 10 Nov 1880 d. 19 Feb 1958 [
=>
]
12
Phoebe Jane Kelsey
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.4.4.12]
b. 23 Aug 1882 d. 16 Jul 1964 [
=>
]
11
Susan Jane Gibson
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.4.5]
b. 11 Oct 1842 d. 25 May 1929
John Franklin Sanders
b. 5 Mar 1830 d. 18 Mar 1896
12
Phebe Jane Sanders
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.4.5.1]
b. 23 Jan 1866 d. 9 May 1950 [
=>
]
12
Amanda Ann Sanders
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.4.5.2]
b. 14 Nov 1867 d. Aug 1868
12
Amy Elmira Sanders
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.4.5.3]
b. 8 Aug 1869 d. 25 Sep 1925
12
William Franklin Sanders
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.4.5.4]
b. 6 Jan 1872 d. 15 Nov 1906
12
Ellen Clymena Sanders
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.4.5.5]
b. 14 Jan 1874 d. 8 Oct 1953 [
=>
]
12
Joseph Myron Sanders
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.4.5.6]
b. 12 Mar 1876 d. 8 Jun 1944 [
=>
]
11
Jemima Gibson
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.4.6]
b. 1847
10
Carum Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.5]
b. 12 Aug 1815 d. 1843
10
Gerua Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.6]
b. 12 Aug 1815 d. 18 Sep 1848
10
Nelson Wheeler Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7]
b. 11 Jul 1818 d. 5 Jul 1887
Susan Jane Bailey
b. 9 Mar 1828 d. 5 Jun 1856
11
Son Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.1]
b. 15 Oct 1844 d. 15 Oct 1844
11
Miranda Jane Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.2]
b. 14 Mar 1847 d. 29 Dec 1907
+
John Williams
b. 8 Oct 1840 d. 21 May 1899
David R Barton
b. 1835
12
David Albert Barton
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.2.1]
b. 22 Jan 1865 d. 3 Sep 1930
12
Elizabeth M Barton
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.2.2]
b. Apr 1868 d. 15 Oct 1917 [
=>
]
12
Mary Ellen Barton
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.2.3]
b. 26 Jul 1870 d. 2 Feb 1926 [
=>
]
Henry Codd
b. 21 Aug 1836 d. 20 Jan 1911
12
Eliza Isabella Code
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.2.4]
b. 12 Nov 1873 d. 13 Mar 1911
12
Charles Levi Code
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.2.5]
b. 3 Apr 1876 d. 4 May 1954
12
Ruth Lorena Code
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.2.6]
b. 21 Apr 1880 d. 16 Nov 1939
12
Theda Maria Code
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.2.7]
b. 2 Jul 1883 d. 11 Jun 1932
11
Mary Janet Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.3]
b. 14 Feb 1849 d. Nov 1922
Charles Maynard
b. Abt 1849
12
Charles Maynard
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.3.1]
b. 1880
+
Richard Marlin Wadams
b. 4 Aug 1852 d. 11 Apr 1914
11
George Nelson Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.4]
b. 20 Mar 1851 d. 8 Jun 1912
Annie Baird
b. 5 Nov 1860 d. 1926
12
William Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.4.1]
b. Abt 1883 d. Abt 1888
12
Frank Henry Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.4.2]
b. 6 Dec 1885 d. 5 Sep 1946 [
=>
]
12
Edson George Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.4.3]
b. 25 Apr 1891 d. 4 Mar 1939
12
Ida Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.4.4]
b. Abt 1899 d. 4 Jun 1899
12
Mary Jannett Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.4.5]
b. 16 Apr 1900 d. 3 Aug 1900
12
Edith May Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.4.6]
b. 21 Nov 1903 d. 9 Oct 1945 [
=>
]
11
Edson Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.5]
b. 10 Oct 1853 d. 26 Feb 1909
Mary Ann Beck
b. 13 Jun 1865 d. 16 Jan 1937
12
Mary Magdaline Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.5.1]
b. 8 Oct 1881 d. 24 Feb 1964 [
=>
]
12
Susan Jane Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.5.2]
b. 17 Oct 1883 d. 25 Apr 1965 [
=>
]
12
William Edson Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.5.3]
b. 19 Oct 1885 d. 10 Mar 1976 [
=>
]
12
Luella Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.5.4]
b. 10 Jan 1888 d. 20 Feb 1924 [
=>
]
12
Amy Louisa Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.5.5]
b. 21 Sep 1890 d. 27 Mar 1972 [
=>
]
12
Delilah Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.5.6]
b. 16 Oct 1893 d. 25 Oct 1976 [
=>
]
12
Stanley Dean Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.5.7]
b. 13 Nov 1896 d. 25 Nov 1896
12
Leon Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.5.8]
b. 14 Jul 1899 d. 17 Jul 1966 [
=>
]
12
Vern George Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.5.9]
b. 10 Jan 1902 d. 9 May 1991
12
Kenneth Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.5.10]
b. 13 Jun 1904 d. 4 Apr 1973
11
Harriet Emily Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.6]
b. 21 Nov 1855 d. 4 Oct 1856
11
Annie Bard Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.7]
b. 5 Jun 1856
Susan Ann Gay
b. 13 Jun 1841 d. 29 Sep 1911
11
Martha Ellen Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.8]
b. 19 Jan 1858 d. 20 Oct 1937
Jacob Kesler
b. 30 Sep 1860 d. 25 Dec 1937
12
Hazel Gay Kesler
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.8.1]
b. 2 Apr 1884 d. 20 Dec 1956 [
=>
]
12
Essie Parthenia Kesler
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.8.2]
b. 23 Oct 1885 d. 29 Jul 1935
12
Frederick Nelson Kesler
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.8.3]
b. 22 Oct 1888 d. 13 Nov 1898
12
Dela Von Kesler
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.8.4]
b. 22 Feb 1890 d. 17 Jul 1934
12
Audrey Kesler
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.8.5]
b. 8 Jun 1893 d. 20 Apr 1897
12
Jacob Waldemar Kesler
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.8.6]
b. 23 Jan 1896 d. 8 Feb 1896
12
Martha Ellen Kesler
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.8.7]
b. 10 Sep 1897
11
Nelson Gay Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.9]
b. 21 Sep 1859 d. 2 Apr 1944
Susannah Wanless
b. 25 Apr 1866 d. 5 Jun 1949
12
William Nelson Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.9.1]
b. 22 Dec 1884 d. 30 May 1972 [
=>
]
12
John Gay Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.9.2]
b. 12 May 1887 d. 25 Jan 1949
12
James Anor Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.9.3]
b. 24 Feb 1889 d. 23 Jun 1946 [
=>
]
12
Raymond Leigh Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.9.4]
b. 17 May 1892 d. 9 Sep 1940
12
Marvian Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.9.5]
b. 11 Sep 1896 d. 26 Aug 1898
12
Frederick Dale Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.9.6]
b. 18 Mar 1908 d. 2 Oct 1960
11
Sylvia Gay Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.10]
b. 18 May 1862 d. 20 Jan 1940
Frederick Bateman Margetts
b. 9 Oct 1861 d. 7 Feb 1950
12
Fred Lynn Margetts
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.10.1]
b. 25 Sep 1885 d. 7 Jan 1971
12
Dora Estella Margetts
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.10.2]
b. 5 Mar 1887 d. 24 Jan 1963 [
=>
]
12
Paul Gay Margetts
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.10.3]
b. 12 Dec 1889 d. 6 Apr 1982 [
=>
]
12
Lucille Margetts
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.10.4]
b. 4 Mar 1893 d. 29 Oct 1959
12
Amy Jane Margetts
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.10.5]
b. 4 Oct 1895 d. 19 Feb 1952
12
Susan Ann Margetts
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.10.6]
b. 30 Mar 1898 d. 10 Oct 1995 [
=>
]
12
Anor Whipple Margetts
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.10.7]
b. 28 Feb 1900 d. 15 Apr 1969 [
=>
]
12
Nelson Whipple Margetts
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.10.8]
b. 2 Sep 1903 d. 20 Sep 1962 [
=>
]
11
Susan Ann Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.11]
b. 3 Nov 1864 d. 19 Dec 1935
Archer Walters Clayton
b. 10 Apr 1858 d. 27 Oct 1947
12
Archer Lynne Clayton
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.11.1]
b. 7 Jul 1883 d. 14 Oct 1952 [
=>
]
12
Don Carlos Clayton
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.11.2]
b. 15 Jan 1885 d. 14 Oct 1964 [
=>
]
12
Phyllis Clayton
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.11.3]
b. 29 Jun 1887 d. 13 Aug 1962 [
=>
]
12
Daughter Clayton
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.11.4]
b. 1889
12
Susan Ann Clayton
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.11.5]
b. 24 Dec 1891 d. 8 Jul 1977 [
=>
]
12
Alonzo Hyde Clayton
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.11.6]
b. 25 Apr 1893 d. 12 Apr 1984 [
=>
]
12
Ruth Clayton
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.11.7]
b. 16 Aug 1895 d. 12 May 1896
12
William Arthur Clayton
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.11.8]
b. 30 Aug 1897 d. 28 Jan 1980 [
=>
]
11
Alexander Samuel Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.12]
b. 2 Mar 1867 d. 8 Jan 1899
Sarah "Daisy" Van Natta
b. 8 May 1870 d. 18 Apr 1962
12
Mary Irene Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.12.1]
b. 16 Oct 1891 d. 5 Mar 1989 [
=>
]
12
Ida Jane Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.12.2]
b. 28 Jun 1894 d. 20 Feb 1968
11
Robert John Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.13]
b. 13 Nov 1869 d. 6 Nov 1954
Susie Winn
b. 10 Feb 1874 d. 8 Sep 1963
12
Ora Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.13.1]
b. 6 May 1897 d. 28 Apr 1956
12
Winnie Leath Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.13.2]
b. 21 Sep 1899 d. 23 Jun 1997 [
=>
]
12
Essie June Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.13.3]
b. 27 Jun 1902 d. 3 Jan 1984 [
=>
]
12
Byron John Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.13.4]
b. 15 Mar 1905 d. 19 Aug 1994 [
=>
]
12
Mildred Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.13.5]
b. 16 Nov 1907 d. 7 May 1987
12
Miriam Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.13.6]
b. 16 Nov 1907 d. 29 Jan 1981 [
=>
]
11
Amey Jane Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.14]
b. 15 Dec 1871 d. 6 Sep 1962
John Henry Evans
b. 29 Apr 1872 d. 24 Mar 1947
12
Emerson Whipple Evans
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.14.1]
b. 7 Apr 1901 d. 26 Mar 1973 [
=>
]
12
Alexander Whipple Evans
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.14.2]
b. 4 Aug 1902 d. 20 Apr 1954 [
=>
]
12
John Henry Evans, Jr
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.14.3]
b. 27 Jan 1903 d. 23 Jun 1988 [
=>
]
12
Gwendolyn Whipple Evans
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.14.4]
b. 2 Feb 1904 d. 21 Sep 1986 [
=>
]
12
Amy Evans
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.14.5]
b. 14 Feb 1909 d. 26 Dec 2001
12
Daughter Evans
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.14.6]
b. 20 Sep 1914 d. 20 Sep 1914
11
Ida Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.15]
b. 15 Dec 1873 d. 21 May 1956
Ezra Oakley Taylor
b. 20 May 1863 d. 19 Jul 1952
12
Mary Whipple Taylor
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.15.1]
b. 11 Feb 1897 d. 16 Apr 1953
12
Julia Whipple Taylor
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.15.2]
b. 6 Aug 1900 d. 27 Apr 1989 [
=>
]
12
Ezra Whipple Taylor
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.15.3]
b. 25 May 1904 d. 21 Jul 2001 [
=>
]
12
Ida Gay Taylor
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.15.4]
b. 19 Oct 1908 d. 23 Dec 2001
12
Irvin Whipple Taylor
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.15.5]
b. 16 Jul 1911 d. 4 Jul 1991 [
=>
]
12
Patricia Taylor
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.15.6]
b. 17 Mar 1919 d. 27 Sep 1997
11
Anor Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.16]
b. 25 Mar 1879 d. 23 Oct 1967
Aurilla May Watkins
b. 4 May 1884 d. 18 Apr 1976
12
Aurilla Gay Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.16.1]
b. 20 Aug 1918 d. 5 Mar 2011 [
=>
]
12
Roswell Watkins Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.16.2]
b. 4 Dec 1922 d. 1 Feb 2008
12
Helen Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.16.3]
b. 5 Feb 1926 d. 6 May 2009
Rachel Keeling
b. 10 Mar 1818 d. 16 Jun 1910
11
Daniel Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.17]
b. 12 Apr 1854 d. 12 Feb 1926
Ellen Hirst
b. 3 Feb 1862 d. 21 Dec 1935
12
Daniel LeRoy Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.17.1]
b. 28 Jul 1879 d. 7 Aug 1935 [
=>
]
12
George Wheeler Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.17.2]
b. 4 Aug 1881 d. 30 Sep 1965 [
=>
]
12
John Ernest Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.17.3]
b. 19 Feb 1883 d. 25 Jan 1946
12
Ella Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.17.4]
b. 27 Jan 1884 d. 29 Sep 1935 [
=>
]
12
Leonard Hirst Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.17.5]
b. 7 Jan 1887 d. 11 Nov 1970 [
=>
]
12
Orley Keeling Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.17.6]
b. 6 Apr 1895 d. 24 Sep 1962 [
=>
]
12
Eugene Brook "Dean" Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.17.7]
b. 29 Dec 1899 d. 31 May 1968 [
=>
]
11
Cynthia Delight Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.18]
b. 7 Jun 1857 d. 4 Sep 1858
11
Nelson Wheeler Whipple, Jr
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.19]
b. 15 Apr 1859 d. 30 Jun 1938
Mary Roberts
b. 15 Jul 1857 d. 23 Sep 1935
12
John Wheeler Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.19.1]
b. 19 Oct 1881 d. 3 Aug 1954 [
=>
]
12
Mable Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.19.2]
b. 4 Jul 1883 d. 8 Oct 1951 [
=>
]
12
Rachel Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.19.3]
b. 20 Dec 1885 d. 1 Jul 1886
12
Nelson Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.19.4]
b. 13 Mar 1887 d. 13 Mar 1887
12
Adelaide Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.19.5]
b. 5 May 1888 d. 21 Feb 1898
12
Lawrence Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.19.6]
b. 24 Sep 1891 d. 2 Apr 1934
12
Lillie May Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.19.7]
b. 6 May 1894 d. 20 Dec 1983 [
=>
]
12
Leslie Whipple
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.7.19.8]
b. 1 Oct 1898 d. Oct 1957 [
=>
]
Zenos Aldrich
b. Abt 1773 d. 8 Nov 1856
10
Sylvanus Aldrich
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.8]
b. 1799 d. 8 Nov 1856
10
Azuba Aldrich
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.9]
b. Abt 1801
Armstrong Baskins
b. 3 Apr 1786 d. 27 May 1842
11
Sarah Ann Baskins
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.9.1]
b. Abt 1824
11
Harriet N Baskins
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.9.2]
b. Abt 1830
11
Mary Jane Baskins
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.9.3]
b. 1832 d. 22 Dec 1850
11
Erastus Baskins
[1.5.6.5.6.1.2.1.9.9.4]
b. 1834 d. 3 Nov 1862
9
Azuba Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.10]
b. 22 Aug 1779 d. 13 Nov 1865
Jared Patchen
b. 5 Sep 1773 d. 1 May 1857
10
Martin Ray Patchen
[1.5.6.5.6.1.2.1.10.1]
b. 10 Feb 1799 d. 7 Feb 1842
10
Abigail Patchen
[1.5.6.5.6.1.2.1.10.2]
b. 23 Jan 1801 d. 7 Sep 1823
10
Emily Patchen
[1.5.6.5.6.1.2.1.10.3]
b. 1802 d. 16 Jul 1826
10
John Patchen
[1.5.6.5.6.1.2.1.10.4]
b. 14 Jan 1803 d. 23 Oct 1874
10
Ira Patchen
[1.5.6.5.6.1.2.1.10.5]
b. 10 Jun 1805
10
Polly Patchen
[1.5.6.5.6.1.2.1.10.6]
b. 20 Jan 1808 d. 21 Aug 1891
10
Mary Patchen
[1.5.6.5.6.1.2.1.10.7]
b. 20 Jan 1808 d. 23 Feb 1888
10
Jared Patchen
[1.5.6.5.6.1.2.1.10.8]
b. 6 Sep 1812
10
Sylvanus Aldridge Patchen
[1.5.6.5.6.1.2.1.10.9]
b. 27 Nov 1814 d. 10 Feb 1892
10
Azuba Ann Patchen
[1.5.6.5.6.1.2.1.10.10]
b. 4 Jun 1817 d. 29 Sep 1886
10
Hannah Lavinia Patchen
[1.5.6.5.6.1.2.1.10.11]
b. 24 Apr 1820
10
Samuel Lorenzo Patchen
[1.5.6.5.6.1.2.1.10.12]
b. 1 Aug 1823 d. 14 Jun 1867
10
Amy Patchen
[1.5.6.5.6.1.2.1.10.13]
b. Abt 5 Jul 1825
9
Phoebe Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.11]
b. 22 Aug 1781 d. 31 Dec 1855
Nathan S Stewart
b. 7 Mar 1771 d. 7 Aug 1866
10
Horace S Stewart
[1.5.6.5.6.1.2.1.11.1]
b. 15 Jun 1804 d. 7 Aug 1866
10
Erastus A Stewart
[1.5.6.5.6.1.2.1.11.2]
b. 10 Mar 1805 d. 10 Nov 1851
10
Elijah Burr Stewart
[1.5.6.5.6.1.2.1.11.3]
b. Abt 1809 d. 9 Nov 1880
10
Azuba Ann Stewart
[1.5.6.5.6.1.2.1.11.4]
b. 1810
10
Samuel Curtis Stewart
[1.5.6.5.6.1.2.1.11.5]
b. 1811 d. 25 Nov 1870
10
William Stewart
[1.5.6.5.6.1.2.1.11.6]
b. 1812
10
Azubam Stewart
[1.5.6.5.6.1.2.1.11.7]
b. 1812
10
Thomas Ryler Stewart
[1.5.6.5.6.1.2.1.11.8]
b. 1815
9
Amy Tiffany
[1.5.6.5.6.1.2.1.12]
b. 8 Dec 1783 d. 17 Dec 1857
Isaac Darrow
b. Abt 1779
10
John Tiffany Darrow
[1.5.6.5.6.1.2.1.12.1]
b. 17 Nov 1800 d. 13 Nov 1897
10
Affa Ward Darrow
[1.5.6.5.6.1.2.1.12.2]
b. 26 Dec 1803 d. 15 Apr 1875
10
Hannah Mead Darrow
[1.5.6.5.6.1.2.1.12.3]
b. 24 Apr 1806
10
Mary Cromwell Darrow
[1.5.6.5.6.1.2.1.12.4]
b. 9 May 1808 d. 18 Nov 1877
10
Ann Hubbard Darrow
[1.5.6.5.6.1.2.1.12.5]
b. 27 Mar 1811 d. 24 Jul 1890
10
Susan Pardee Darrow
[1.5.6.5.6.1.2.1.12.6]
b. 1813 d. 24 Jun 1890
8
Zachariah Curtis
[1.5.6.5.6.1.2.2]
b. 1745
Sarah
b. 1749
9
Mary Curtis
[1.5.6.5.6.1.2.2.1]
c. 18 Aug 1771
9
James Curtis
[1.5.6.5.6.1.2.2.2]
c. 9 Apr 1773
9
Ann Curtis
[1.5.6.5.6.1.2.2.3]
c. 15 May 1775
9
Sarah Curtis
[1.5.6.5.6.1.2.2.4]
c. 2 Mar 1777
9
Hannah Curtis
[1.5.6.5.6.1.2.2.5]
c. 14 Feb 1778 d. 20 Feb 1778
9
Esther Curtis
[1.5.6.5.6.1.2.2.6]
c. 14 Feb 1778 d. 18 Jan 1779
9
Zachariah Curtis
[1.5.6.5.6.1.2.2.7]
c. 5 Aug 1781 d. 28 Jul 1782
8
Thomas Curtis
[1.5.6.5.6.1.2.3]
b. 1748 d. 26 Nov 1823
Eunice Peet
b. Nov 1771 d. Abt 1835
9
Charles Curtis
[1.5.6.5.6.1.2.3.1]
b. 1791
9
Ira Curtis
[1.5.6.5.6.1.2.3.2]
b. 15 Mar 1794
9
Philip Curtis
[1.5.6.5.6.1.2.3.3]
b. 1795
9
Son Curtis
[1.5.6.5.6.1.2.3.4]
b. 23 May 1798 d. 23 May 1798
9
William K Curtis
[1.5.6.5.6.1.2.3.5]
b. 22 Dec 1800 d. 1 Mar 1873
9
Elizabeth Curtis
[1.5.6.5.6.1.2.3.6]
b. 27 Nov 1803 d. 13 Jan 1853
9
Amos Curtis
[1.5.6.5.6.1.2.3.7]
b. Abt 1804
9
Huldah Jane Curtis
[1.5.6.5.6.1.2.3.8]
b. 22 Jul 1805 d. 25 Nov 1887
9
Thomas Curtis
[1.5.6.5.6.1.2.3.9]
b. Abt 1806
8
Charity Curtis
[1.5.6.5.6.1.2.4]
b. 1750 d. 25 Mar 1820
8
Nathaniel Curtis
[1.5.6.5.6.1.2.5]
b. 1755
8
Andrew Curtis
[1.5.6.5.6.1.2.6]
b. 18 Jul 1756 d. 5 Nov 1834
Eunice Hall
b. 4 Mar 1770 d. 4 Mar 1839
9
Hull Curtis
[1.5.6.5.6.1.2.6.1]
b. 16 May 1797
9
Miranda Curtis
[1.5.6.5.6.1.2.6.2]
b. 12 Jul 1799 d. 23 Apr 1877
8
Everard Curtis
[1.5.6.5.6.1.2.7]
b. 8 Dec 1758 d. 5 Jul 1846
Clarissa Peet
b. Abt 1772 d. 7 Apr 1827
9
Clarissa Curtis
[1.5.6.5.6.1.2.7.1]
b. Abt 1801
9
Anson Curtis
[1.5.6.5.6.1.2.7.2]
b. Abt 1803 d. 1847
9
Charles Curtis
[1.5.6.5.6.1.2.7.3]
b. 8 Oct 1805 d. 8 Mar 1880
7
Eunice Curtis
[1.5.6.5.6.1.3]
b. 11 Nov 1719 d. 1803
7
Nathaniel Curtis, Jr
[1.5.6.5.6.1.4]
b. Abt 1720 d. 1776
7
Anna Curtis
[1.5.6.5.6.1.5]
b. Abt 1722 d. Bef 12 Mar 1761
7
Judson Curtis
[1.5.6.5.6.1.6]
b. 22 May 1723 d. 23 Mar 1808
7
Charity Curtis
[1.5.6.5.6.1.7]
b. Abt 1726 d. 5 Aug 1773
7
Phebe Curtis
[1.5.6.5.6.1.8]
4
Rebecca Foote
[1.5.6.6]
b. 3 Sep 1634 d. 6 Apr 1701
Lieutenant Philip Smith
b. 30 Apr 1632 d. 10 Jan 1685
5
Charles Smith
[1.5.6.6.1]
b. 2 Jan 1661 d. 22 Jan 1661
5
Deacon John Smith
[1.5.6.6.2]
b. 18 Dec 1661 d. 16 Apr 1727
5
Jonathan Smith
[1.5.6.6.3]
b. Abt 18 Dec 1663 d. Abt 9 Oct 1737
5
Philip Smith
[1.5.6.6.4]
b. 1665 d. 25 Jan 1725
Mary Bliss
b. 14 Aug 1670 d. 23 Dec 1707
6
Philip Smith
[1.5.6.6.4.1]
b. 1 May 1689 d. 1712
6
David Smith
[1.5.6.6.4.2]
b. 23 Apr 1691
6
Martha Smith
[1.5.6.6.4.3]
b. 27 Sep 1694 d. 1750
6
Samuel Smith
[1.5.6.6.4.4]
b. Abt 1696 d. 28 Aug 1777
6
Aaron Smith
[1.5.6.6.4.5]
b. 14 Feb 1697
6
Mary Smith
[1.5.6.6.4.6]
b. 23 Feb 1699 d. Aft 1774
6
Samuel Smith
[1.5.6.6.4.7]
b. 10 Dec 1701
6
Rebecca Smith
[1.5.6.6.4.8]
b. 18 Apr 1705 d. 3 Feb 1788
6
Ebenezer Smith
[1.5.6.6.4.9]
b. 1 Jan 1707
6
Nehemiah Smith
[1.5.6.6.4.10]
b. 17 Jul 1709 d. 1745
5
Rebecca Smith
[1.5.6.6.5]
b. 1668 d. 7 Oct 1750
5
Nathanial Smith
[1.5.6.6.6]
b. 1671 d. 1740
5
Joseph Smith
[1.5.6.6.7]
b. 1674 d. 8 Sep 1736
3
Caleb Foote
[1.5.7]
b. 1595 d. 1635
3
David Foote
[1.5.8]
b. 1597
3
Joshua Foote
[1.5.9]
b. Abt 1600 d. 31 Oct 1655
3
Phoebe Foote
[1.5.10]
b. 26 Feb 1602 d. 31 Oct 1655
3
Samuel Foote
[1.5.11]
b. 1603 d. Aft 1665