Home Page
|
What's New
|
Photos
|
Histories
|
Headstones
|
Reports
|
Surnames
Search
First Name:
Last Name:
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Suomalainen
Svenska
John West
1527 - 1600 (73 years)
Submit Photo / Document
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Submit Photo / Doc
Worksheet
Family
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
John West
[1]
b. 1527 d. 1600
Mary Throckmorton
b. 1529
2
Nicholas West
[1.1]
b. 1551 d. 21 Oct 1601
Anne Benedict
b. 1555 d. 5 Jun 1595
3
Richard West
[1.1.1]
b. 6 Feb 1579 d. 24 Mar 1643
Eliabeth Hall
b. Abt 1579
4
Joane West
[1.1.1.1]
b. 16 Apr 1606 d. 18 May 1654
John White
b. 13 Jul 1600 d. 23 Jan 1684
5
John White, Jr
[1.1.1.1.1]
b. 1 Jun 1628 d. 15 Apr 1691
Frances Jackson
b. 1625 d. 26 Feb 1696
6
Benjamin White
[1.1.1.1.1.1]
b. 5 Jan 1656 d. 9 Jan 1723
Susanna Cogswell
b. 5 Jan 1657 d. 9 Jan 1723
7
Susanna White
[1.1.1.1.1.1.1]
b. 25 Mar 1683
7
Ann White
[1.1.1.1.1.1.2]
b. 1685 d. 10 Sep 1743
Peter Boylston
b. 1673 d. 10 Sep 1743
8
Susannah Hannah Boylston
[1.1.1.1.1.1.2.1]
b. 5 Mar 1699 d. 17 Apr 1797
John Adams
b. 8 Feb 1691 d. 25 May 1761
9
President John Adams
[1.1.1.1.1.1.2.1.1]
b. 19 Oct 1735 d. 4 Jul 1826
Abigail Quincy Smith
b. 22 Nov 1744 d. 28 Oct 1818
10
Abigail Amelia "Nabby" Adams
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.1]
b. 14 Jul 1765 d. 9 Aug 1813
10
President John Quincy Adams
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.2]
b. 11 Jul 1767 d. 23 Feb 1848
Louisa Catherine Johnson
b. 12 Feb 1775 d. 15 May 1852
11
George Washington Adams
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1]
b. 12 Apr 1801 d. 9 Jun 1829
11
John Adams, II
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.2]
b. 4 Jul 1803 d. 23 Oct 1834
11
Charles Frances Adams
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.3]
b. 18 Aug 1807 d. 21 Nov 1886
11
Louisa Catherine Adams
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.4]
b. 12 Aug 1811 d. 15 Sep 1812
10
Susanna Adams
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.3]
b. 28 Dec 1768 d. 4 Feb 1770
10
Charles Adams
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.4]
b. 29 May 1770 d. 30 Nov 1800
10
Thomas Boylston Adams
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.5]
b. 15 Sep 1772 d. 13 Mar 1832
10
Elizabeth Adams
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.6]
b. 11 Jul 1777 d. 11 Jul 1777
9
Peter Boylston Adams
[1.1.1.1.1.1.2.1.2]
b. 16 Oct 1738 d. 2 Jun 1823
9
Elihu Adams
[1.1.1.1.1.1.2.1.3]
b. 29 Mar 1741 d. 18 Mar 1776
8
Benjamin Boylston
[1.1.1.1.1.1.2.2]
b. 19 Apr 1705 d. 1760
8
Jerusha Boylston
[1.1.1.1.1.1.2.3]
b. 3 Feb 1718 d. Feb 1797
7
Mary White
[1.1.1.1.1.1.3]
b. 27 Aug 1688 d. 23 Jan 1749
7
Edward White
[1.1.1.1.1.1.4]
b. 10 Jul 1693
7
Joanna White
[1.1.1.1.1.1.5]
b. 4 Nov 1701
7
Elizabeth White
[1.1.1.1.1.1.6]
b. 4 Nov 1701
5
Thomas White
[1.1.1.1.2]
b. 30 Jun 1630 bur. 10 Oct 1672
5
Joanna White
[1.1.1.1.3]
b. 24 Feb 1633 d. 14 May 1695
5
Elizabeth White
[1.1.1.1.4]
b. 29 Jul 1635 d. 10 Feb 1676
Captain Henry Kerley
b. Abt 1627 d. 27 Jan 1711
6
Henry Kerley
[1.1.1.1.4.1]
b. 1657 d. 2 Feb 1674
6
William Kerley
[1.1.1.1.4.2]
b. 1658 d. 2 Feb 1674
6
Bartholomew Kerley
[1.1.1.1.4.3]
b. Abt 1659 d. 1746
6
Elizabeth Kerley
[1.1.1.1.4.4]
b. Abt 1660 d. 1735
Daniel Howe
b. 3 Jan 1658 d. 28 Jan 1718
7
Martha Howe
[1.1.1.1.4.4.1]
b. 13 Jul 1687
7
Hezakiah Howe
[1.1.1.1.4.4.2]
b. 19 Jun 1690
7
Daniel Howe
[1.1.1.1.4.4.3]
b. 1692
7
Jonathan Howe
[1.1.1.1.4.4.4]
b. 23 Apr 1695 d. 25 Jul 1738
7
Elizabeth Howe
[1.1.1.1.4.4.5]
b. 13 Oct 1697 d. 16 Apr 1776
Captain Robert Barnard
b. 28 Mar 1689 d. 13 May 1773
8
William Bernard
[1.1.1.1.4.4.5.1]
b. Abt 1727 d. 25 Mar 1793
Mary Fleming
b. 21 Mar 1728 d. 25 Mar 1793
9
Lieutenant William Bernard
[1.1.1.1.4.4.5.1.1]
b. 1750 d. 27 Apr 1776
9
Robert Bernard
[1.1.1.1.4.4.5.1.2]
b. Abt 1752
9
Daughter Bernard
[1.1.1.1.4.4.5.1.3]
b. 1754
9
Thomas Bernard
[1.1.1.1.4.4.5.1.4]
b. Mar 1756 d. 11 Jun 1834
9
Catherine Bernard
[1.1.1.1.4.4.5.1.5]
b. 1758 d. Feb 1831
William Bennett
b. Abt 1755 d. May 1823
10
Mary Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.1]
b. 6 Mar 1776 d. 16 Aug 1847
10
Elisha Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.2]
b. Abt 1777 d. Bef 14 Oct 1839
10
Elizabeth Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.3]
b. 23 Aug 1782
10
Richard Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.4]
b. 30 Mar 1785 d. 30 Aug 1835
+
Mary Bell
b. 5 Dec 1786 d. 12 Apr 1856
10
Martha Jane Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.5]
b. Abt 1786 d. 20 Oct 1871
10
Lucy Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.6]
b. Abt 1788 d. Aft 1850
10
William Junior Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7]
b. 22 Jul 1790 d. 1 Oct 1846
Elizabeth Bell
b. 4 Nov 1792 d. 5 Nov 1864
11
Austin Bell Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.1]
b. 11 Dec 1814 d. 8 Jul 1896
Angelina Storm
b. 8 Nov 1818 d. 25 Sep 1854
12
John J Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.1.1]
b. Abt 1839 [
=>
]
12
Eli Preston Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.1.2]
b. Abt 1840 [
=>
]
12
Sarah Ann Elizabeth Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.1.3]
b. 14 Aug 1842 d. 30 Apr 1934 [
=>
]
12
Adolphus J Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.1.4]
b. 1842
12
Samuel Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.1.5]
b. Abt 1847 d. Abt 1919 [
=>
]
12
William Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.1.6]
b. 1848 d. Bef 1896 [
=>
]
12
David L Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.1.7]
b. 14 Jun 1851 d. 13 Dec 1932
12
Vina J Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.1.8]
b. 1854 d. 6 Oct 1854
Lucretia Jane Aldridge
b. 8 Feb 1831 d. 5 Mar 1910
12
Mary Angeline Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.1.9]
b. 1857 [
=>
]
12
Thomas F Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.1.10]
b. 1860 d. Bef 1896
12
Eliza Jane Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.1.11]
b. 1862 [
=>
]
12
Hiram Washington Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.1.12]
b. 1866 d. 21 Jun 1910 [
=>
]
12
Patrick Henry Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.1.13]
b. 1869 d. 1946 [
=>
]
11
Thomas McGuire Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.2]
b. 24 Feb 1816 d. 24 Feb 1894
Sarah Bennett
b. 1815
12
Elizabeth E Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.2.1]
b. 22 Jan 1837 d. 2 May 1911 [
=>
]
12
Thomas J Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.2.2]
b. Nov 1839
12
Margaret F Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.2.3]
b. 1842
12
James Washington Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.2.4]
b. 25 Jul 1857 d. 25 Apr 1920 [
=>
]
Margaret Lavina Wilson
b. 22 Feb 1815 d. 30 Oct 1907
12
William Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.2.5]
b. 25 May 1849 d. 23 Aug 1904 [
=>
]
11
Sarah Ann Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.3]
b. 8 Oct 1817
11
Eliza Catherine Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.4]
b. 19 Jan 1819
Samuel Downes
b. 1830 d. 16 Jan 1894
12
Samuel Downes
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.4.1]
b. 1854
12
Elizabeth Downes
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.4.2]
b. 1856
12
Arthur Downes
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.4.3]
b. 1857 [
=>
]
12
Frederick Downes
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.4.4]
b. 1860
11
Mary Jane Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.5]
b. 1 Jan 1821 d. 25 Jun 1852
Jesse Temple McCauslin
b. 24 Feb 1817 d. 6 Mar 1884
12
William Y McCauslin
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.5.1]
b. Abt 1850 d. 8 Apr 1865
12
Sally McCauslin
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.5.2]
b. Abt 1848 d. 26 Jun 1852
11
Hiram Bell Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.6]
b. 1 Mar 1823 d. 17 Aug 1912
Martha Smith
b. 9 Jun 1817 d. 12 Oct 1902
12
Henry Bell Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.6.1]
b. Jun 1846 d. Jun 1846
12
Hyrum William Asahel Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.6.2]
b. 22 Nov 1848 d. 9 Jan 1849
12
Martha Eliza Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.6.3]
b. 24 Jan 1849 d. 6 May 1924 [
=>
]
12
Ezra Melanthorn Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.6.4]
b. 20 Oct 1851 d. 25 Aug 1852
12
Emily Jane Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.6.5]
b. 17 Jan 1854 d. 4 May 1903 [
=>
]
12
Elizabeth Emma Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.6.6]
b. 2 Jul 1856 d. 26 Feb 1940 [
=>
]
12
Elias Austin Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.6.7]
b. 26 Jan 1858 d. 1 May 1861
Ellen Greenhalgh
b. 27 Jul 1851 d. 4 May 1890
12
Jesse Johnson Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.6.8]
b. 25 Jul 1869 d. 22 Sep 1949 [
=>
]
12
George Alfred Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.6.9]
b. 27 Apr 1871 d. 27 Apr 1943 [
=>
]
12
Sarah Ellen Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.6.10]
b. 9 Feb 1873 d. 13 Jun 1961 [
=>
]
12
Esther Pricilla Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.6.11]
b. 20 Sep 1874 d. 1 Apr 1966
12
Mary Alice Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.6.12]
b. 4 Nov 1876 d. 17 Jun 1972 [
=>
]
12
Lucy Belle Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.6.13]
b. 4 Jul 1878 d. 6 Feb 1968 [
=>
]
12
Minnie Margaret Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.6.14]
b. 15 Apr 1880 d. 29 Jul 1961 [
=>
]
12
Clara Marinda Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.6.15]
b. 3 Feb 1883 d. 27 Sep 1966
12
Edith Ann Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.6.16]
b. 3 Jan 1885 d. 9 Jul 1947 [
=>
]
12
Albert Eli Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.6.17]
b. 20 Mar 1887 d. 11 Aug 1953 [
=>
]
12
Peter Preston Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.6.18]
b. 4 Oct 1888 d. 1 Dec 1967 [
=>
]
11
William M Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.7]
b. 4 Nov 1824
11
Martha Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.8]
b. 4 Jun 1825 d. 25 Dec 1867
William James Calkins
b. 17 Oct 1822 d. 10 Jun 1892
12
Eliza Ann Calkins
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.8.1]
b. 28 Jan 1854 d. 26 May 1930 [
=>
]
12
Martha Emeline Calkins
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.8.2]
b. Abt 1858 d. 1860
12
William Cyril Calkins, Jr
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.8.3]
b. 10 Aug 1864 d. 10 Jul 1929 [
=>
]
12
Alfred Arden Calkins
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.8.4]
b. 23 Dec 1867 d. 26 Dec 1867
11
George Alfred Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.9]
b. 4 May 1828 d. 18 Apr 1906
Lucy Ann Susan Saxey
b. 13 Jan 1842 d. 15 Jan 1892
12
Hannah Louisa Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.9.1]
b. 8 May 1860 d. 27 Aug 1921 [
=>
]
12
John Alfred Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.9.2]
b. 1 Jul 1864 d. 24 Jul 1948 [
=>
]
12
Mary Ellen Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.9.3]
b. 23 Sep 1866 d. 3 Feb 1928 [
=>
]
12
Elizabeth Lucy Ann Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.9.4]
b. 24 Aug 1861 d. 2 Nov 1893 [
=>
]
12
Willey Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.9.5]
b. 1869
12
George W Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.9.6]
b. 10 Dec 1869 d. 4 Jan 1936
12
Rosalle Elvira Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.9.7]
b. 15 Oct 1852 d. 20 Jul 1939 [
=>
]
12
William Daniel Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.9.8]
b. 10 Dec 1884 d. 18 Aug 1958 [
=>
]
12
Albert Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.9.9]
b. May 1885 d. 7 Jul 1923
11
John Bell Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.10]
b. 16 May 1830 d. 2 Feb 1902
Mary Senior
b. 2 Mar 1839 d. 20 May 1891
12
Mary Catherine Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.10.1]
b. 24 Oct 1863 d. 1864
12
John William Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.10.2]
b. 1864 d. 1864
12
Austin Robert Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.10.3]
b. 14 Jan 1866 d. 22 Sep 1942 [
=>
]
12
Ellen Elizabeth Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.10.4]
b. 1867 d. 1867
12
William Hyrum Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.10.5]
b. 27 Oct 1869 d. 24 Apr 1947 [
=>
]
12
George Edward Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.10.6]
b. 19 Mar 1871 d. 3 Jan 1874
12
John Bell Bennett, Jr
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.10.7]
b. 11 Oct 1872 d. 28 Feb 1946 [
=>
]
12
David Alfred Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.10.8]
b. 8 Aug 1874 d. 11 Oct 1945 [
=>
]
12
Sidney Redfern Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.10.9]
b. 18 Nov 1876 d. 27 Sep 1877
12
Samuel Senior Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.10.10]
b. 18 Nov 1876 d. 20 Jan 1951 [
=>
]
12
Joseph McGuire Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.10.11]
b. 13 Sep 1878 d. 4 Jan 1944 [
=>
]
12
Franklin Tennyson Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.10.12]
b. 21 Aug 1881 d. 25 Oct 1957 [
=>
]
11
Nancy Ellen Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.11]
b. 4 Jul 1833 d. 20 Mar 1909
Jesse Temple McCauslin
b. 24 Feb 1817 d. 6 Mar 1884
12
Mary Jane McCauslin
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.11.1]
b. 16 Apr 1854 d. 14 Jul 1939 [
=>
]
12
Sarah Ann McCauslin
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.11.2]
b. 29 Aug 1855 d. 30 Jan 1932 [
=>
]
12
Lydia Ellen McCauslin
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.11.3]
b. 1 May 1856 d. 3 Sep 1858
12
Caroline McCauslin
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.11.4]
b. 14 Nov 1858 d. 23 Sep 1930 [
=>
]
12
Jesse B McCauslin
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.11.5]
b. 13 Sep 1860 d. 16 Dec 1909 [
=>
]
12
George A McCauslin
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.11.6]
b. 6 Dec 1862 d. 12 Apr 1865
12
Alonzo McCauslin
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.11.7]
b. 1 May 1865 d. 22 May 1865
12
Elizabeth Mahala McCauslin
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.7.11.8]
b. 6 Jan 1867 d. 27 Jul 1933 [
=>
]
10
Clarissa Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.8]
b. Abt 1795 d. 1850
10
Catherine Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.9]
b. Abt 1796 d. Aft 1826
10
Nancy Bennett
[1.1.1.1.4.4.5.1.5.10]
b. Abt 1797 d. Aft 1826
9
Daniel Bernard
[1.1.1.1.4.4.5.1.6]
b. Abt 1760
9
Elizabeth Bernard
[1.1.1.1.4.4.5.1.7]
b. Abt 1762 d. 1788
9
Mary Fleming Bernard
[1.1.1.1.4.4.5.1.8]
b. Abt 1764 d. 16 May 1834
9
Richard Fleming Bernard
[1.1.1.1.4.4.5.1.9]
b. 18 Mar 1767 d. 16 May 1834
8
John Bernard
[1.1.1.1.4.4.5.2]
b. Abt 1729 d. 1799
8
Robert Bernard
[1.1.1.1.4.4.5.3]
b. Abt 1730
8
Frances Bernard
[1.1.1.1.4.4.5.4]
b. Abt 1730 d. 1810
8
Elizabeth Bernard
[1.1.1.1.4.4.5.5]
b. 3 Jun 1730
8
Joel Bernard
[1.1.1.1.4.4.5.6]
b. 3 Jul 1732 d. 15 Aug 1775
8
Peter Bernard
[1.1.1.1.4.4.5.7]
b. Abt 1733 d. 1780
8
Abigail Bernard
[1.1.1.1.4.4.5.8]
b. 28 Apr 1734
8
Soloman Bernard
[1.1.1.1.4.4.5.9]
b. 27 Sep 1735 d. 1 Aug 1775
8
Margaret Bernard
[1.1.1.1.4.4.5.10]
b. 1737 d. Abt 1819
8
Martha Bernard
[1.1.1.1.4.4.5.11]
b. 26 Apr 1740 d. 10 Aug 1807
8
John Bernard
[1.1.1.1.4.4.5.12]
b. 19 May 1743 d. 19 May 1825
8
Sarah Bernard
[1.1.1.1.4.4.5.13]
b. 1745
7
David Howe
[1.1.1.1.4.4.6]
b. 17 Apr 1700 d. 1746
7
Zerviah Howe
[1.1.1.1.4.4.7]
b. 1702 d. 10 Dec 1723
6
Mary Kerley
[1.1.1.1.4.5]
b. 14 Aug 1666 d. 28 Dec 1728
6
Joseph Kerley
[1.1.1.1.4.6]
b. 1668 d. 2 Feb 1674
6
Sarah Kerley
[1.1.1.1.4.7]
b. 14 Oct 1668
5
Josiah White
[1.1.1.1.5]
b. 4 Jun 1643 d. 11 Nov 1714
3
Nicholas West
[1.1.2]
b. 26 Feb 1580 d. 1 May 1580
3
Nicholas West
[1.1.3]
b. Mar 1583
3
John West
[1.1.4]
b. 24 Mar 1585 d. 15 Apr 1577
3
William West
[1.1.5]
c. 3 Sep 1575
2
Aholiab West
[1.2]
b. Abt 1553 d. 1628
2
Sarah West
[1.3]
b. 1555