Home Page
|
What's New
|
Photos
|
Histories
|
Headstones
|
Reports
|
Surnames
Search
First Name:
Last Name:
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Suomalainen
Svenska
Isabel Kaye
Abt 1583 - 1635 (52 years)
Submit Photo / Document
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Submit Photo / Doc
Worksheet
Family
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Isabel Kaye
[1]
b. Abt 1583 d. 10 Dec 1635
Henrie Dunster
b. 1577 d. 16 Sep 1646
2
Isabel Dunster
[1.1]
b. 1603 bur. 10 Jun 1611
2
John Dunster
[1.2]
b. Abt 1606 bur. 24 Sep 1644
2
Margaret Dunster
[1.3]
b. 1607 d. 20 Aug 1625
2
Henry Dunster
[1.4]
b. 26 Nov 1609 d. 27 Feb 1660
2
Richard Dunster
[1.5]
b. Abt 1610 d. Bef 1659
2
Thomas Dunster
[1.6]
b. 1611 d. Aft 1640
2
Mary Dunster
[1.7]
b. Abt 1618 d. May 1667
2
Deborah Dunster
[1.8]
b. Abt 1620
2
John Dunster
[1.9]
b. Abt 1623
2
Elizabeth Dunster
[1.10]
b. 25 Oct 1629 d. 26 Dec 1693
Behanuel Bower
b. 1621 d. 1680
3
Ellen Bowers
[1.10.1]
b. 1641 d. 1695
John Lees
b. 31 May 1640
4
John Leigh
[1.10.1.1]
b. Feb 1665
Mrs Leigh
b. Abt 1669
5
Cornelius Leigh
[1.10.1.1.1]
b. Jul 1673
5
Sarah Leigh
[1.10.1.1.2]
b. Feb 1676
5
Mary Leigh
[1.10.1.1.3]
b. Jan 1678
5
John Leigh
[1.10.1.1.4]
b. Feb 1678
5
Elizabeth Leigh
[1.10.1.1.5]
b. May 1680
5
Sarah Leigh
[1.10.1.1.6]
b. Feb 1682
5
James Leigh
[1.10.1.1.7]
b. Jul 1683
5
William Leigh
[1.10.1.1.8]
b. Jul 1686
5
Martha Leigh
[1.10.1.1.9]
b. Abt 1693
4
Jane Lees
[1.10.1.2]
b. 1669
4
Mary Lees
[1.10.1.3]
b. 21 May 1671
Abraham Hall
c. 3 Jan 1669
5
Elizabeth Hall
[1.10.1.3.1]
c. 11 Sep 1698
5
John Hall
[1.10.1.3.2]
c. 22 Jun 1701
5
Mary Hall
[1.10.1.3.3]
c. 22 Aug 1703 bur. 8 Mar 1796
Joseph Mellor
c. 17 Apr 1698 d. 18 Jan 1790
6
John Mellor
[1.10.1.3.3.1]
c. 24 Feb 1723 bur. 26 Jan 1730
6
James Mellor
[1.10.1.3.3.2]
c. 25 Apr 1725 bur. 5 Feb 1737
6
Hanna Mellor
[1.10.1.3.3.3]
c. 12 Feb 1729
Abraham Wilde
b. 24 Feb 1716 d. 1787
7
Anne Wilde
[1.10.1.3.3.3.1]
b. Abt 1754
Abraham Buckley
c. 13 Oct 1751
8
James Buckley
[1.10.1.3.3.3.1.1]
b. Abt 1775
8
Joseph Buckley
[1.10.1.3.3.3.1.2]
b. Abt 1779
8
Frances Buckley
[1.10.1.3.3.3.1.3]
b. Abt 1781
7
Sarah Wilde
[1.10.1.3.3.3.2]
c. 1 Aug 1755
7
Mary Wilde
[1.10.1.3.3.3.3]
c. 2 Apr 1758
7
Joseph Wilde
[1.10.1.3.3.3.4]
c. 7 Oct 1759
7
Elizabeth "Betty" Wilde
[1.10.1.3.3.3.5]
c. 3 May 1761
7
John Wilde
[1.10.1.3.3.3.6]
b. 15 Sep 1764
7
Benjamin Wilde
[1.10.1.3.3.3.7]
c. 30 May 1768 d. 1842
Mary Jones
c. 22 May 1763 bur. 16 Mar 1832
8
Hannah Maria Wilde
[1.10.1.3.3.3.7.1]
b. 6 Nov 1791 d. 23 Mar 1861
8
Mary Wilde
[1.10.1.3.3.3.7.2]
b. 4 Oct 1792
8
Sarah Wilde
[1.10.1.3.3.3.7.3]
b. 1793 d. Dec 1874
+
Luke Nield
b. 13 Oct 1796 d. 23 Jul 1869
8
Betty Wilde
[1.10.1.3.3.3.7.4]
b. 24 Jan 1796
8
Martha Wilde
[1.10.1.3.3.3.7.5]
b. 8 Feb 1797 d. 25 Jun 1854
Luke Nield
b. 13 Oct 1796 d. 23 Jul 1869
9
Benjamin Nield
[1.10.1.3.3.3.7.5.1]
b. 1 Aug 1817 d. Aug 1874
Jane Schofield
b. 23 Jun 1821 d. Abt 1896
10
Ann Nield
[1.10.1.3.3.3.7.5.1.1]
b. 1 Aug 1838 d. Abt 1861
10
Martha Nield
[1.10.1.3.3.3.7.5.1.2]
b. 20 Jul 1840 d. 29 Mar 1856
10
John Eli Nield
[1.10.1.3.3.3.7.5.1.3]
b. 16 Aug 1842
10
Sarah Nield
[1.10.1.3.3.3.7.5.1.4]
b. 14 Oct 1844
10
Luke James Nield
[1.10.1.3.3.3.7.5.1.5]
b. 9 Nov 1847
10
William Nield
[1.10.1.3.3.3.7.5.1.6]
b. 15 Dec 1849 d. 4 May 1851
9
Joseph Nield
[1.10.1.3.3.3.7.5.2]
b. 5 May 1819 d. 24 Feb 1821
9
Joseph Merrick Nield
[1.10.1.3.3.3.7.5.3]
b. 4 Jul 1822 d. 22 Dec 1897
Jane Standring
b. 31 May 1827 d. 4 May 1896
10
Martha Alice Nield
[1.10.1.3.3.3.7.5.3.1]
b. 14 Jan 1855 d. 1 Aug 1926
Benjamin Goddard
b. 27 Jul 1851 d. 5 Dec 1930
11
Joshua Percy Goddard
[1.10.1.3.3.3.7.5.3.1.1]
b. 6 Dec 1879 d. 1 Jun 1966
10
Mary Nield
[1.10.1.3.3.3.7.5.3.2]
b. 2 Oct 1857 d. 19 Feb 1858
10
Emma Jane Nield
[1.10.1.3.3.3.7.5.3.3]
b. 19 Apr 1861 d. 22 Dec 1940
+
Benjamin Goddard
b. 27 Jul 1851 d. 5 Dec 1930
10
Luke Charles Nield
[1.10.1.3.3.3.7.5.3.4]
b. 3 Nov 1864 d. 22 Dec 1888
10
Hannah Nield
[1.10.1.3.3.3.7.5.3.5]
b. 21 Aug 1856 d. 28 Dec 1935
William Henry Stott
b. 5 May 1830 d. 28 Mar 1906
11
Ernest Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.3.5.1]
b. 23 Mar 1882 d. 23 Mar 1882
11
Franklin Earl Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.3.5.2]
b. 19 Feb 1883 d. 25 Sep 1965
Ida Sophia Fisher
b. 4 Dec 1885 d. 3 Mar 1964
12
Reeta Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.3.5.2.1]
b. 1 Aug 1908 d. 13 Dec 1998
12
Vera Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.3.5.2.2]
b. 13 Nov 1912 d. 9 Oct 1994
12
Ruth Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.3.5.2.3]
b. 31 Aug 1916 d. 29 Oct 2004 [
=>
]
12
Earl Reed Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.3.5.2.4]
b. 29 Dec 1922 d. 4 Jun 1998
12
Melvin Henry Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.3.5.2.5]
b. 22 Sep 1924 d. 2 Sep 2004
11
Alice Ada Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.3.5.3]
b. 31 Jul 1884 d. 1 Mar 1971
Neil Murdoch Stewart
b. 10 Feb 1887 d. 23 Jul 1972
12
William Harold Stewart
[1.10.1.3.3.3.7.5.3.5.3.1]
b. 30 Jun 1909 d. 25 Aug 1996 [
=>
]
12
James Alvin Stewart
[1.10.1.3.3.3.7.5.3.5.3.2]
b. 23 Aug 1911 d. 19 Sep 1979 [
=>
]
12
Beulah Stewart
[1.10.1.3.3.3.7.5.3.5.3.3]
b. 4 Oct 1913 d. 17 May 2002
12
Neil Stott Stewart
[1.10.1.3.3.3.7.5.3.5.3.4]
b. 25 Aug 1917 d. 29 Apr 2014 [
=>
]
12
Ruth Stewart
[1.10.1.3.3.3.7.5.3.5.3.5]
b. 16 Mar 1923 d. 25 Dec 2016 [
=>
]
12
Benjamin Stewart
[1.10.1.3.3.3.7.5.3.5.3.6]
b. 26 Mar 1925 d. 26 Mar 1925
11
James William Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.3.5.4]
b. 3 Nov 1885 d. 2 Jan 1974
Della Alberta Cunningham
b. 20 May 1888 d. 10 Nov 1973
12
Leon James Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.3.5.4.1]
b. 2 Mar 1907 d. 21 Jul 1987 [
=>
]
12
Girven Cunningham Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.3.5.4.2]
b. 18 Sep 1908 d. 13 Jul 1996 [
=>
]
12
Eldon Rawlins Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.3.5.4.3]
b. 21 Oct 1911 d. 21 Nov 1999 [
=>
]
12
Vonda Hannah Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.3.5.4.4]
b. 9 Jun 1915 d. 24 May 2003 [
=>
]
12
Benjamin Don Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.3.5.4.5]
b. 19 Mar 1920 d. 1 Aug 1993
12
Laural Hyrum Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.3.5.4.6]
b. 15 Apr 1921 d. 14 Mar 2000
12
Lloyd Donald Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.3.5.4.7]
b. 5 Jun 1924 d. 14 Mar 2019 [
=>
]
12
Cleo Gail Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.3.5.4.8]
b. 20 Mar 1928 d. 4 Mar 2013 [
=>
]
11
Ethel Edna Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.3.5.5]
b. 31 Jan 1888 d. 3 Oct 1964
Elmer J Duncan
b. 8 Mar 1884 d. 19 Mar 1963
12
Floyd E Duncan
[1.10.1.3.3.3.7.5.3.5.5.1]
b. 23 Oct 1911 d. 4 Oct 1994 [
=>
]
12
Lola Duncan
[1.10.1.3.3.3.7.5.3.5.5.2]
b. 11 Apr 1915 d. 25 Jan 2006 [
=>
]
12
James Stanley Duncan
[1.10.1.3.3.3.7.5.3.5.5.3]
b. 20 Sep 1916 d. 29 Aug 2001 [
=>
]
12
William Kenneth Duncan
[1.10.1.3.3.3.7.5.3.5.5.4]
b. 20 Nov 1920 d. 8 Jul 1984 [
=>
]
12
Edna Duncan
[1.10.1.3.3.3.7.5.3.5.5.5]
b. 29 Aug 1924 d. 30 Aug 1924
12
Elmer Stott Duncan
[1.10.1.3.3.3.7.5.3.5.5.6]
b. 2 Dec 1926 d. 3 Jun 2019 [
=>
]
11
Rulon Henry Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.3.5.6]
b. 10 Jun 1889 d. 26 May 1960
Clara Etta Williamson
b. 10 Apr 1890 d. 7 Sep 1947
12
Owen R Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.3.5.6.1]
b. 1 Apr 1913 d. 2 Apr 1917
12
William Grant Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.3.5.6.2]
b. 17 Jun 1914 d. 3 Mar 1998
12
Ila Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.3.5.6.3]
b. 1 Mar 1918 d. 13 Dec 2003
12
Lila Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.3.5.6.4]
b. 1 Mar 1918 d. 27 Jun 2005 [
=>
]
12
Emma Clara Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.3.5.6.5]
b. 17 May 1924 d. 15 May 2002 [
=>
]
12
Emmett Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.3.5.6.6]
b. 17 May 1924 d. 17 May 1924
11
Charles Orval Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.3.5.7]
b. 14 May 1894 d. 24 Oct 1964
Flora Bushnell
b. 10 Sep 1894 d. 3 Nov 1978
12
Verna Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.3.5.7.1]
b. 12 Aug 1917 d. 3 Jul 1974
12
Merlene Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.3.5.7.2]
b. 24 Mar 1919 d. 26 Mar 2008 [
=>
]
12
Flora Ruth Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.3.5.7.3]
b. 11 Jul 1925 d. 5 Jul 2011
9
Rebecca Nield
[1.10.1.3.3.3.7.5.4]
b. 31 Aug 1824 bur. 18 Apr 1860
William Hutchinson
b. Abt 1820 d. 16 Nov 1892
10
Luke James Hutchinson
[1.10.1.3.3.3.7.5.4.1]
b. 28 Dec 1854
Jane Fernley
b. 29 May 1849
11
Rebecca Hutchinson
[1.10.1.3.3.3.7.5.4.1.1]
b. 1877
11
William Hutchinson
[1.10.1.3.3.3.7.5.4.1.2]
b. 1880
11
John William "Willie" Hutchinson
[1.10.1.3.3.3.7.5.4.1.3]
b. 1881
11
Samuel Hutchinson
[1.10.1.3.3.3.7.5.4.1.4]
b. 1883
11
Son Hutchinson
[1.10.1.3.3.3.7.5.4.1.5]
b. Abt 1885
11
Rebecca Hutchinson
[1.10.1.3.3.3.7.5.4.1.6]
b. Abt 1887
11
Walter Hutchinson
[1.10.1.3.3.3.7.5.4.1.7]
b. 1890
10
John Hutchinson
[1.10.1.3.3.3.7.5.4.2]
b. 2 Oct 1858 d. 6 Feb 1946
Sarah Jane Butterworth
b. 2 Jun 1858 d. 11 Oct 1937
11
Samuel Hutchinson
[1.10.1.3.3.3.7.5.4.2.1]
b. 16 Sep 1879 d. 5 Mar 1964
11
John Hutchinson
[1.10.1.3.3.3.7.5.4.2.2]
b. 28 Oct 1882 d. Apr 1883
11
Annie Hutchinson
[1.10.1.3.3.3.7.5.4.2.3]
b. 14 May 1884 d. Nov 1887
11
John Hutchinson
[1.10.1.3.3.3.7.5.4.2.4]
b. 24 Jun 1888 d. 26 Nov 1958
Gladys Maude Bitson
b. 13 Mar 1890 d. 12 May 1964
12
Emerson Hutchinson
[1.10.1.3.3.3.7.5.4.2.4.1]
b. 12 Sep 1910 d. 19 Aug 1964
11
Lucy Hutchinson
[1.10.1.3.3.3.7.5.4.2.5]
b. 6 May 1891 d. 11 Nov 1976
+
John William Malseed
b. 2 Oct 1890 d. 12 Jul 1970
11
Ethelyn Hutchinson
[1.10.1.3.3.3.7.5.4.2.6]
b. 22 May 1894 d. 24 Jul 1980
Raymond Siddoway
b. 23 Jun 1895 d. 8 May 1969
12
Vernon Raymond Siddoway
[1.10.1.3.3.3.7.5.4.2.6.1]
b. 26 Feb 1917 d. 10 Jun 1929
Robert William Hatch
b. 12 Sep 1894 d. 30 Aug 1973
12
Lee Rueben Hatch
[1.10.1.3.3.3.7.5.4.2.6.2]
b. 10 Apr 1928 d. 10 Jun 1991
11
Annie Hutchinson
[1.10.1.3.3.3.7.5.4.2.7]
b. 12 Jun 1897 d. 28 Jun 1984
+
E Forrest Taylor
b. Abt 1904 d. 19 Feb 1965
10
Samuel Hutchinson
[1.10.1.3.3.3.7.5.4.3]
b. 1860
10
Mary Ann Hutchinson
[1.10.1.3.3.3.7.5.4.4]
b. 1862
+
Jim Wilies
b. Abt 1860
10
Ellen Hutchinson
[1.10.1.3.3.3.7.5.4.5]
b. Abt 1864
9
Hannah Nield
[1.10.1.3.3.3.7.5.5]
b. 18 Mar 1827 bur. 19 Nov 1835
9
Mary Nield
[1.10.1.3.3.3.7.5.6]
b. 15 Jul 1829 d. 21 Dec 1829
9
Daniel Nield
[1.10.1.3.3.3.7.5.7]
b. 25 May 1831 d. 25 May 1831
9
John Nield
[1.10.1.3.3.3.7.5.8]
b. 23 Feb 1834 d. 14 Dec 1913
Sarah Broadbent
b. 19 Jul 1833 d. 10 Jun 1901
10
Orson William Nield
[1.10.1.3.3.3.7.5.8.1]
b. 8 Dec 1853 d. 23 Apr 1854
10
John Edward Nield
[1.10.1.3.3.3.7.5.8.2]
b. 24 Nov 1855 d. 13 Aug 1925
10
Hannah Nield
[1.10.1.3.3.3.7.5.8.3]
b. 28 Feb 1858 d. 26 Jan 1936
10
Joseph Luke Nield
[1.10.1.3.3.3.7.5.8.4]
b. 9 Jul 1860 d. 31 Dec 1936
10
Daniel Broadbent Nield
[1.10.1.3.3.3.7.5.8.5]
b. 19 Feb 1863 d. 27 May 1876
10
Benjamin Franklin Nield
[1.10.1.3.3.3.7.5.8.6]
b. 2 Apr 1865 d. 2 Apr 1865
10
Thomas Taylor Nield
[1.10.1.3.3.3.7.5.8.7]
b. 28 Aug 1866 d. 11 May 1929
10
James Wild Nield
[1.10.1.3.3.3.7.5.8.8]
b. 2 Jun 1869 d. 26 Jan 1956
10
Sarah Elizabeth Nield
[1.10.1.3.3.3.7.5.8.9]
b. 28 Nov 1872 d. 21 Jul 1955
10
Seth Broadbent Nield
[1.10.1.3.3.3.7.5.8.10]
b. 2 Jul 1875 d. 15 May 1949
9
Ann Nield
[1.10.1.3.3.3.7.5.9]
b. 1 Aug 1838 d. Bef 1851
9
Alice Nield
[1.10.1.3.3.3.7.5.10]
b. 20 Oct 1836 d. 1 Oct 1877
William Henry Stott
b. 5 May 1830 d. 28 Mar 1906
10
Martha Alice Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.1]
b. 14 Aug 1856 d. 12 Mar 1931
Hyrum Adams
b. 22 Oct 1846 d. 17 Jun 1923
11
Bessie Alice Adams
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.1.1]
b. 28 Jun 1877 d. 17 Nov 1959
William Henry Gull
b. 2 Jul 1869 d. 24 Jun 1954
12
Irah William Gull
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.1.1.1]
b. 21 Jun 1897 d. 1 Jan 1929 [
=>
]
12
Leon Henry Gull
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.1.1.2]
b. 1 Oct 1899 d. 31 Aug 1949
12
Etta Alice Gull
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.1.1.3]
b. 21 Jan 1902 d. 4 Apr 1969 [
=>
]
12
Arma J Gull
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.1.1.4]
b. 14 Mar 1907 d. 30 Dec 1960 [
=>
]
12
Percy Gull
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.1.1.5]
b. 19 Mar 1909 d. 12 Jun 1919
11
Martha Ann Adams
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.1.2]
b. 3 Nov 1879 d. 8 Jun 1915
Albert Edward Gull
b. 17 May 1877 d. 14 Jul 1954
12
Thora Aretta Gull
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.1.2.1]
b. 16 Jul 1906 d. Jun 2000
11
Mary Hannah Adams
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.1.3]
b. 28 Oct 1882 d. 27 Jan 1981
Nephi David Beckstrand
b. 1 Nov 1878 d. 10 May 1957
12
Austin N Beckstrand
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.1.3.1]
b. 29 May 1914 d. 8 Nov 2005
12
Evan A Beckstrand
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.1.3.2]
b. 16 Nov 1917 d. 31 Jan 2007
12
Lucile Beckstrand
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.1.3.3]
b. 11 Feb 1923 d. 1 Nov 1931
11
Hyrum Vincent Adams
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.1.4]
b. 23 Mar 1885 d. 25 Oct 1948
Amy Elizabeth Bushnell
b. 20 Dec 1886 d. 24 Aug 1974
12
LaVerre Vincent Adams
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.1.4.1]
b. 11 May 1906 d. 20 May 1982
12
Leland Bushnell Adams
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.1.4.2]
b. 9 Oct 1907 d. 13 Dec 1976 [
=>
]
12
Loyd Hyrum Adams
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.1.4.3]
b. 24 Mar 1910 d. 21 Dec 1965 [
=>
]
12
Idonna Adams
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.1.4.4]
b. 3 Mar 1912 d. 26 Jun 1997
12
Vanetta Adams
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.1.4.5]
b. 16 Aug 1913 d. 6 Feb 1990 [
=>
]
12
Luella Adams
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.1.4.6]
b. 10 Dec 1916 d. 4 Apr 1997 [
=>
]
12
Mark J Adams
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.1.4.7]
b. 28 Nov 1918 d. 23 Jun 1965
12
Alice Adams
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.1.4.8]
b. 12 Mar 1921 d. 27 Dec 1929
12
Colleen Adams
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.1.4.9]
b. 13 Nov 1926 d. 17 May 2020
11
Sylvester Samuel Adams
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.1.5]
b. 22 Jan 1888 d. 19 Oct 1965
Sarah Amanda Bracken
b. 20 Apr 1891 d. 27 Dec 1958
12
McKenney Adams
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.1.5.1]
b. 22 Dec 1920 d. 25 Mar 2007
12
Marie Adams
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.1.5.2]
b. 3 Jun 1923 d. 7 Aug 2007 [
=>
]
12
Reed S Adams
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.1.5.3]
b. 11 Mar 1926 d. 1 Nov 1983
12
Living
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.1.5.4]
11
Joseph William Adams
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.1.6]
b. 10 Jul 1890 d. 11 Jul 1890
11
Irvin Henry Adams
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.1.7]
b. 10 Jul 1890 d. 23 Jul 1890
10
Sarah Rebecca Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.2]
b. 18 Mar 1858 d. 13 Sep 1940
Joseph Smith Dame
b. 17 Mar 1856 d. 16 May 1929
11
Alice Lavina Dame
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.2.1]
b. 15 Sep 1880 d. 24 Jan 1962
John Alma Watts
b. 20 Apr 1877 d. 6 Apr 1933
12
John Clayton Watts
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.2.1.1]
b. 5 Jun 1900 d. 15 Jun 1978 [
=>
]
12
Alton Fay Watts
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.2.1.2]
b. 4 Aug 1904 d. 28 Nov 1907
12
Orvil Arlin Watts
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.2.1.3]
b. 14 Nov 1906 d. 28 Oct 2000
12
Ruth Dame Watts
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.2.1.4]
b. 8 Sep 1909 d. 14 May 1995 [
=>
]
12
Elaine Dame Watts
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.2.1.5]
b. 20 Jan 1914 d. 4 Sep 1938
12
Verdun Austin Watts
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.2.1.6]
b. 6 Feb 1918 d. 8 Mar 2009 [
=>
]
11
Emma Lees Dame
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.2.2]
b. 8 Sep 1882 d. 27 Aug 1885
11
Rebecca Jane Dame
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.2.3]
b. 12 Jan 1885 d. 9 Oct 1955
William Henry Reay
b. 5 May 1886 d. 15 Jun 1948
12
Don Reay
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.2.3.1]
b. 16 Apr 1910 d. 28 Jun 1990
12
Lee Reay
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.2.3.2]
b. 9 Apr 1912 d. 17 Jun 2001
12
Delmar H Reay
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.2.3.3]
b. 16 Mar 1914 d. 19 Oct 2000 [
=>
]
12
Von Reay
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.2.3.4]
b. 12 Aug 1915 d. 25 Dec 1983 [
=>
]
12
Claree Reay
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.2.3.5]
b. 30 Sep 1917 d. 9 Nov 2007 [
=>
]
12
Fay Reay
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.2.3.6]
b. 29 Dec 1920 d. 30 Jan 2005
11
Joseph Ezra Dame
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.2.4]
b. 28 Jan 1887 d. 22 May 1971
Charlotte Bushnell
b. 1 Dec 1888 d. 19 Oct 1965
12
Alton Fay Dame
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.2.4.1]
b. 24 Dec 1912 d. 31 Mar 1968 [
=>
]
12
Helen Dame
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.2.4.2]
b. 28 Jul 1914 d. 2 Apr 2001
12
Ezra Orren Dame
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.2.4.3]
b. 14 Jul 1916 d. 17 Mar 1985
12
Roland Stott Dame
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.2.4.4]
b. 15 Jan 1920 d. 12 Jul 2003 [
=>
]
12
Ellen Mae Dame
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.2.4.5]
b. 14 Apr 1921 d. 4 Jul 2009
12
Evelyn Dame
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.2.4.6]
b. 28 Sep 1925 d. 20 Jan 2008
12
Verla Dame
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.2.4.7]
b. 17 Jan 1934 d. 16 Jul 2005
11
William Fenton Dame
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.2.5]
b. 28 May 1892 d. 24 Jun 1973
Esther Doul Benson
b. 1 Oct 1891 d. 28 May 1983
12
Marion Dame
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.2.5.1]
b. 4 Oct 1918 d. 7 Dec 1965
12
William Benson Dame
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.2.5.2]
b. 9 Oct 1920
12
Lorraine Dame
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.2.5.3]
b. 2 Jul 1923 d. 24 Jul 2001
11
Noble Dame
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.2.6]
b. 28 Mar 1896 d. 31 Jan 1936
10
William Henry Stott, Jr
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.3]
b. 7 Jul 1860 d. 17 Jan 1934
Agnes Jane Rogers
b. 2 Jun 1864 d. 18 Jul 1942
11
Son Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.3.1]
b. 6 Jun 1883 d. 6 Jun 1883
11
John William Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.3.2]
b. 12 Oct 1884 d. 8 Sep 1968
+
Thyra Elizabeth Nilson
b. 29 Aug 1893 d. 3 Jan 1915
Johanna Jacoba Bierens
b. 10 Nov 1887 d. 22 Sep 1923
12
John William Stott, Jr
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.3.2.1]
b. 4 Sep 1918 d. 12 Aug 2012
12
Thyra Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.3.2.2]
b. 15 Oct 1922 d. Nov 1922
Elsie Mary Strauser
b. 29 Sep 1891 d. 16 Mar 1973
12
Helen Elizabeth Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.3.2.3]
b. 6 May 1928 d. 3 Oct 2017
12
Mary Alice Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.3.2.4]
b. 30 Sep 1932 d. 6 Jan 2013
11
Edgar Luke Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.3.3]
b. 16 Jun 1887 d. 15 Jan 1971
Florence Ricks
b. 21 Jun 1893 d. 3 Jan 1975
12
Joseph Lynde Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.3.3.1]
b. 23 Jan 1917 d. 26 Nov 2008 [
=>
]
12
Edgar Keith Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.3.3.2]
b. 23 Aug 1919 d. 23 Apr 2003 [
=>
]
12
Florence Lila Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.3.3.3]
b. 12 Aug 1923 d. 8 Mar 2020
12
William Earl Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.3.3.4]
b. 5 Nov 1926 d. 27 Jul 2013 [
=>
]
12
Agnes Leah Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.3.3.5]
b. 26 Jan 1929 d. 7 Apr 1929
12
Raymond Eugene Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.3.3.6]
b. 21 Jan 1931 d. 7 Dec 2019
11
Son Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.3.4]
b. 1889 d. 1889
11
Edna Agnes Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.3.5]
b. 30 Jul 1890 d. 23 Jan 1978
Adrian Anthony Pirie
b. 8 Apr 1883 d. 15 Mar 1950
12
William Adrian Pirie
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.3.5.1]
b. 24 Aug 1914 d. 11 Feb 2005
12
Agnes Edna Pirie
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.3.5.2]
b. 9 Aug 1917 d. 10 May 1970
11
Ruby Alice Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.3.6]
b. 22 Sep 1892 d. 22 Sep 1892
11
Clinton Rogers Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.3.7]
b. 17 Apr 1894 d. 19 Jul 1985
Cecile Adilla Pillers
b. 6 Jun 1897 d. 10 Nov 1993
12
Hazel Agnes Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.3.7.1]
b. 31 Oct 1917 d. 4 Dec 1986
12
Thrya Cecile Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.3.7.2]
b. 28 Jul 1922 d. 6 Apr 1990
12
William Hart Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.3.7.3]
b. 23 Mar 1925 d. 11 Mar 2011
11
Lynde Lees Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.3.8]
b. 17 Jan 1897 d. 9 Jan 1989
+
Erma Rachel Riley
b. 25 Aug 1901 d. 15 May 1971
+
Mildred Flora Strauser
b. 12 Feb 1903 d. 22 Feb 1969
11
Florence Stott Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.3.9]
b. 27 Feb 1899 d. 22 May 1975
+
Edward Woolford Bowden
b. 9 May 1903 d. 14 Nov 1986
11
Floyd Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.3.10]
b. 4 Jun 1901 d. 30 May 1985
Nora Leavitt
b. 18 Apr 1904 d. 29 May 2006
12
Geraldine Agnes Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.3.10.1]
b. 6 Jan 1930 d. 9 Sep 1994
12
Fay Leavitt Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.3.10.2]
b. 9 Dec 1931 d. 8 Aug 2007
12
Daniel Floyd Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.3.10.3]
b. 14 May 1933 d. 19 Feb 2017
10
Mary Jane Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.4]
b. 2 Sep 1862 d. 19 Sep 1930
David William Duncan
b. 4 Feb 1859 d. 1 Aug 1906
11
Alice Jennette Duncan
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.4.1]
b. 29 Sep 1881 d. 12 Mar 1903
John Edward Anderson
b. 15 May 1873 d. 25 Jan 1939
12
Mary Alys Anderson
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.4.1.1]
b. 5 Mar 1903 d. 6 Mar 1985
11
Mary Elizabeth Duncan
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.4.2]
b. 9 Dec 1883 d. 13 Mar 1911
11
David William Duncan, Jr
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.4.3]
b. 6 Oct 1886 d. 22 Feb 1959
Louie Stringham
b. 15 May 1889 d. 17 Dec 1988
12
David Reed Duncan
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.4.3.1]
b. 3 Sep 1908 d. 2 Oct 2000 [
=>
]
12
Mary Louise Duncan
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.4.3.2]
b. 21 Apr 1910 d. 14 May 1988 [
=>
]
12
Lorraine Duncan
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.4.3.3]
b. 25 Oct 1911 d. 31 May 2005 [
=>
]
12
Joseph Stringham Duncan
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.4.3.4]
b. 7 Jan 1913 d. 11 Feb 1997 [
=>
]
12
J Blair Duncan
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.4.3.5]
b. 26 Nov 1914 d. 22 Feb 1975 [
=>
]
12
Blenda Duncan
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.4.3.6]
b. 7 Dec 1916 d. 7 Jun 2007 [
=>
]
12
Odetta Duncan
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.4.3.7]
b. 26 Aug 1919 d. 16 Jan 1988 [
=>
]
12
Letha Duncan
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.4.3.8]
b. 23 Jun 1921 d. 9 Nov 2009 [
=>
]
11
Lula May Duncan
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.4.4]
b. 17 Feb 1890 d. 18 Dec 1973
Hyrum Bryant Gull
b. 25 Sep 1883 d. 9 Mar 1928
12
Roma Gull
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.4.4.1]
b. 27 Jul 1911 d. 25 Feb 2003 [
=>
]
12
Reva Gull
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.4.4.2]
b. 1 Oct 1916 d. 12 Apr 2005 [
=>
]
12
Aleith Gull
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.4.4.3]
b. 13 Jul 1921 d. 23 Mar 2013 [
=>
]
12
Dwain D Gull
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.4.4.4]
b. 21 Aug 1923 d. 17 May 2015 [
=>
]
11
Laura Jane Duncan
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.4.5]
b. 15 Sep 1892 d. 15 Feb 1981
Joseph Henry Edwards
b. 1 Aug 1891 d. 31 Oct 1961
12
Jarold Duncan Edwards
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.4.5.1]
b. 17 Nov 1914 d. 21 May 1981 [
=>
]
12
Olga Edwards
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.4.5.2]
b. 11 Apr 1919 d. 9 May 1994 [
=>
]
12
Floral Edwards
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.4.5.3]
b. 7 Oct 1921 d. 3 Aug 1998 [
=>
]
12
June Edwards
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.4.5.4]
b. 20 Jun 1929 d. 20 Jun 1929
12
Living
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.4.5.5]
11
Vanda Duncan
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.4.6]
b. 15 Oct 1895 d. 7 Aug 1969
Thomas Charles Swallow
b. 14 Feb 1892 d. 13 May 1980
12
Opal Swallow
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.4.6.1]
b. 21 Dec 1916 d. 11 Sep 2005 [
=>
]
12
Thera Swallow
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.4.6.2]
b. 25 Mar 1920 d. 18 Apr 2002
12
Chad C Swallow
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.4.6.3]
b. 16 Mar 1924 d. 5 Aug 2000
12
Grover Swallow
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.4.6.4]
b. 23 Oct 1927 d. 23 Apr 2009 [
=>
]
12
Shirley Jane Swallow
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.4.6.5]
b. 18 Nov 1930 d. 12 Nov 2014 [
=>
]
11
Verda Duncan
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.4.7]
b. 15 Oct 1895 d. 2 Oct 1985
Arnold Ezra Gull
b. 13 May 1891 d. 20 May 1971
12
Elvin Gull
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.4.7.1]
b. 16 May 1915 d. Oct 1983 [
=>
]
12
Living
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.4.7.2]
12
Verla Gull
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.4.7.3]
b. 16 Apr 1926 d. Jan 1992
11
Joseph Clem Duncan
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.4.8]
b. 20 May 1897 d. 31 May 1990
Retta Lund
b. 4 Feb 1901 d. 4 Feb 1985
12
LaVeda Duncan
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.4.8.1]
b. 29 Apr 1921 d. 10 Jul 2001
12
Melvin Wilson Duncan
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.4.8.2]
b. 27 Dec 1922 d. 27 Aug 2002
12
Claude Lund Duncan
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.4.8.3]
b. 30 Aug 1925 d. 5 Aug 2005
12
Ralph Clem Duncan
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.4.8.4]
b. 25 Aug 1929 d. 6 Mar 2013
12
Living
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.4.8.5]
11
Christena Duncan
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.4.9]
b. 11 Nov 1898 d. 11 Apr 1899
10
Thomas Fenton Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.5]
b. 28 Oct 1864 d. 28 Oct 1864
10
James Elye Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.6]
b. 15 Dec 1866 d. 13 Dec 1867
10
Luke Nield Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.7]
b. 11 Oct 1868 d. 20 Dec 1958
Nina Dame
b. 5 Sep 1868 d. 3 Sep 1943
11
Joseph Lon Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.7.1]
b. 22 Feb 1890 d. 11 Mar 1891
11
Pearl Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.7.2]
b. 22 Sep 1892 d. 11 Feb 1978
Solomon Samuel Lowe
b. 2 May 1880 d. 26 Mar 1945
12
Ruth Elizabeth Lowe
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.7.2.1]
b. 17 Mar 1913 d. 20 May 1964
12
Grant Stott Lowe
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.7.2.2]
b. 26 Dec 1914 d. 14 Oct 1969
12
Mary Lovina Lowe
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.7.2.3]
b. 9 Jan 1917 d. 23 Aug 1945
12
Margaret Pearl Lowe
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.7.2.4]
b. 25 Aug 1918 d. 14 Feb 2005
12
Dorothy Eleanor Lowe
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.7.2.5]
b. 18 Aug 1922 d. 25 Nov 2014
12
Alaska Fay Lowe
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.7.2.6]
b. 17 Jan 1925 d. 6 Aug 2000
12
Melvin Richard Lowe
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.7.2.7]
b. 16 Jul 1929 d. 25 Feb 1987 [
=>
]
12
Joyce Louise Lowe
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.7.2.8]
b. 15 Feb 1936 d. 24 Sep 2014
11
Ellen "Ella" Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.7.3]
b. 18 Nov 1894 d. 18 Nov 1894
11
Lorne Lees Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.7.4]
b. 4 Feb 1896 d. 19 Oct 1987
Zina Baker
b. 24 Dec 1899 d. 1 Jul 1990
12
Harry Dean Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.7.4.1]
b. 16 Oct 1920 d. 4 Nov 1996
12
Raymond Lee Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.7.4.2]
b. 2 Oct 1922 d. 29 Aug 1960
11
Luke Nield Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.7.5]
b. 11 Oct 1898 d. 21 Oct 1979
+
Electa Belle Bockover
b. 9 Oct 1886 d. 17 Jan 1969
11
Ruby Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.7.6]
b. 25 Feb 1901 d. 7 Jun 1967
LeRoy Horrace Layton
b. 7 Oct 1900 d. 2 Apr 1977
12
Living
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.7.6.1]
12
Stanley Layton
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.7.6.2]
b. 25 Mar 1935 d. 26 Mar 1935
11
Normon Hayes Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.7.7]
b. 24 Apr 1904 d. 19 Jun 1979
+
Francis Ensel
11
William Lloyd Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.7.8]
b. 23 Feb 1907 d. 12 Nov 1990
+
Modeska Ruth Carr
b. 1905
+
Bernice Hauge
11
Kenneth Edward Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.7.9]
b. 19 Mar 1909 d. 5 Dec 1978
11
Glen Jeffway Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.7.10]
b. 25 Mar 1912 d. 31 Jan 1996
+
Ava Lee Sullivan
+
Lovina Elizabeth Bushnell
b. 22 Oct 1880 d. 25 Nov 1967
10
Joseph Lees Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.8]
b. 25 Jun 1872 d. 27 May 1923
Sarah Ellen Bennett
b. 9 Feb 1873 d. 13 Jun 1961
11
Joseph Leo Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.8.1]
b. 28 Oct 1894 d. 25 Aug 1959
Velma Bushnell
b. 11 Jul 1899 d. 10 Dec 1985
12
Nadine Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.8.1.1]
b. 4 May 1918 d. 2 Nov 2005 [
=>
]
12
Leola Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.8.1.2]
b. 8 Aug 1920 d. 26 Mar 2012
12
Stella Vee Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.8.1.3]
b. 8 Nov 1922 d. 16 Feb 2006 [
=>
]
12
Leo Ben Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.8.1.4]
b. 12 Jun 1931 d. 13 Jun 2003 [
=>
]
12
Joseph B Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.8.1.5]
b. 16 May 1925 d. 20 Mar 2014
12
Norena M Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.8.1.6]
b. 21 Jun 1927 d. 9 Apr 2018 [
=>
]
12
Reah Knoll Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.8.1.7]
b. 3 Aug 1933 d. 11 Sep 2017
11
Cleon Bennett Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.8.2]
b. 23 Aug 1896 d. 17 Apr 1961
Zina Stewart
b. 8 Jul 1895 d. 2 Aug 1986
12
Beth Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.8.2.1]
b. 20 May 1920 d. 10 Feb 1942
12
Verene Ellen Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.8.2.2]
b. 11 May 1924 d. 1 Mar 2003
12
Clea Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.8.2.3]
b. 30 Mar 1926 d. 3 Jul 2016
12
Living
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.8.2.4]
12
Living
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.8.2.5]
12
Living
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.8.2.6]
11
Melba Ellen Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.8.3]
b. 2 Sep 1898 d. 15 Jan 1987
Daniel Dearden Bushnell
b. 18 Dec 1892 d. 1 Oct 1980
12
Joseph Merrill Bushnell
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.8.3.1]
b. 19 Jun 1920 d. 18 Sep 2009 [
=>
]
12
Daniel Stott Bushnell
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.8.3.2]
b. 15 Nov 1923 d. 23 Dec 2002
12
Fred Jewel Bushnell
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.8.3.3]
b. 4 Aug 1928 d. 8 Oct 2016
12
Ted Darrell Bushnell
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.8.3.4]
b. 7 Mar 1934 d. 6 Apr 2017
10
Hyrum Wild Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.9]
b. 27 Jun 1875 d. 19 Jan 1958
Mary Esther Ross
b. 14 Mar 1873 d. 2 Apr 1950
11
Leland Hyrum Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.9.1]
b. 17 Feb 1897 d. 28 Nov 1981
+
Mary Lourine Dougherty
b. 3 Jul 1904 d. 26 Jun 1998
11
Roscoe Wild Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.9.2]
b. 28 Jul 1899 d. 26 May 1964
+
Claudia Louise Waldrum
b. 7 Jun 1913 d. 15 Apr 2003
11
Asael R Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.9.3]
b. 23 Mar 1903 d. 21 Jun 1994
+
Hazel Dell Barnhart
b. 19 Mar 1900 d. 17 Jun 1974
11
Percy Lynn Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.9.4]
b. 4 Dec 1920 d. 16 Nov 1995
LaReta May Thompson
b. 18 Aug 1930 d. 12 Apr 2012
12
Jeffrey Lane Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.9.4.1]
b. 19 Sep 1962 d. 28 Jan 2018
10
George Quale Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.10]
b. 8 Sep 1877 d. 29 Dec 1973
Thirza Timbers Ottley
b. 14 Mar 1884 d. 22 Mar 1949
11
George Verdon Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.10.1]
b. 4 Apr 1909 d. 20 May 1970
Bessie Susan Catherine Bullock
b. 14 Feb 1911 d. 21 Oct 1981
12
Carol Bullock Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.10.1.1]
b. 22 Dec 1931 d. 28 Feb 2018
+
Hattie Rachel Ross
b. 22 Aug 1908 d. 23 Dec 1999
11
Arvin Edward Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.10.2]
b. 27 Nov 1910 d. 27 Aug 1992
Selma Loraine Vest
b. 11 May 1916 d. 18 Aug 2005
12
Arvin Vernile Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.10.2.1]
b. 11 Jul 1934 d. 6 Nov 2012
12
Edna La Gene Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.10.2.2]
b. 30 Dec 1942 d. 16 Apr 1981
+
Dora
11
Erma Jessie Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.10.3]
b. 23 Sep 1912 d. 27 Feb 2001
Harold John Evans
b. 17 May 1909 d. 24 Oct 1977
12
Leon Stott Evans
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.10.3.1]
b. 24 Nov 1933 d. 1 May 2017
12
Don Rhuel Evans
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.10.3.2]
b. 16 Feb 1935 d. 15 Dec 2017
12
Paul G Evans
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.10.3.3]
b. 31 Aug 1936 d. 28 Nov 2009
12
Son Evans
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.10.3.4]
b. 9 Jun 1938 d. 9 Jun 1938
12
Daughter Evans
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.10.3.5]
b. 9 Jun 1938 d. 9 Jun 1938
11
Darwin Sidney Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.10.4]
b. 1 Nov 1914 d. 5 Nov 1993
Sarah Louise Spackman
b. 14 Sep 1916 d. 13 Nov 2004
12
Son Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.10.4.1]
b. 29 Sep 1939 d. 3 Oct 1939
12
Son 1 Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.10.4.2]
b. 9 Jun 1957 d. 9 Jun 1957
12
Son 2 Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.10.4.3]
b. 9 Jun 1957 d. 9 Jun 1957
12
Daughter Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.10.4.4]
b. 2 Feb 1959 d. 2 Feb 1959
11
Rolla William Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.10.5]
b. 30 Nov 1916 d. 16 Sep 1988
Gwena Joyce Myers
b. 21 May 1918 d. 16 Nov 2002
12
Robert M Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.10.5.1]
12
Von R Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.10.5.2]
b. 18 Sep 1942 d. 24 Feb 2010
12
Anita S Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.10.5.3]
11
Horace Ottley Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.10.6]
b. 10 Feb 1920 d. 23 Apr 2008
+
Nina Cleora Fleener
b. 25 Sep 1915 d. 2 Sep 1993
11
Hyrum Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.10.7]
b. 10 Feb 1920 d. 14 Feb 1920
11
Joseph Percy Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.10.8]
b. 24 Sep 1923 d. 10 Jun 2017
LaDawn Riddle
b. 9 Mar 1925 d. 29 Jul 2014
12
Daughter Stott
[1.10.1.3.3.3.7.5.10.10.8.1]
b. 29 Feb 1944 d. 29 Feb 1944
8
Ann Wilde
[1.10.1.3.3.3.7.6]
b. 8 Aug 1798
8
Abraham Wilde
[1.10.1.3.3.3.7.7]
b. Abt 1799 d. 1799
8
Abraham Wilde
[1.10.1.3.3.3.7.8]
c. 9 Aug 1801 d. 9 Aug 1801
8
Jonathan Wilde
[1.10.1.3.3.3.7.9]
b. 13 Nov 1802
8
Joseph Wilde
[1.10.1.3.3.3.7.10]
b. 10 Jan 1806
8
Charles Wilde
[1.10.1.3.3.3.7.11]
b. 9 May 1809
6
Edmund Mellor
[1.10.1.3.3.4]
c. 1 Nov 1730 bur. 30 Jan 1734
6
Joseph Mellor
[1.10.1.3.3.5]
c. 22 Jan 1731 d. 16 Dec 1755
6
Mary Mellor
[1.10.1.3.3.6]
c. 30 Apr 1732 d. 16 Apr 1799
6
Thomas Mellor
[1.10.1.3.3.7]
c. 5 Apr 1734
6
Hannah Mellor
[1.10.1.3.3.8]
c. 5 Apr 1734
6
Sarah Mellor
[1.10.1.3.3.9]
c. 3 Oct 1736 bur. 4 Feb 1800
James Wilde
b. Abt 1735
7
Benjamin Wilde
[1.10.1.3.3.9.1]
c. 26 Jun 1768
7
Joseph Wilde
[1.10.1.3.3.9.2]
b. 1768 d. 30 Apr 1829
7
John Wilde
[1.10.1.3.3.9.3]
b. 1770
6
Alice Mellor
[1.10.1.3.3.10]
c. 23 Jul 1738 bur. 15 Jun 1819
6
John Mellor
[1.10.1.3.3.11]
c. 24 Oct 1742
6
Betty Mellor
[1.10.1.3.3.12]
c. 3 Apr 1746 bur. 15 Jan 1832
Daniel Knott
b. Abt 1742
7
Thomas Knott
[1.10.1.3.3.12.1]
c. 22 Nov 1772
7
David Knott
[1.10.1.3.3.12.2]
c. 9 Oct 1774
7
Sarah Knott
[1.10.1.3.3.12.3]
c. May 1783
5
Anne Hall
[1.10.1.3.4]
c. 29 Jul 1705
5
Sara Hall
[1.10.1.3.5]
c. 7 Sep 1707
5
Martha Hall
[1.10.1.3.6]
c. 9 Oct 1709
5
Jonathan Hall
[1.10.1.3.7]
c. 25 May 1712 d. 11 Feb 1713
4
Ann Lees
[1.10.1.4]
c. 4 Sep 1670
4
Robert Lees
[1.10.1.5]
c. 26 Aug 1673
4
Jonathan Lees
[1.10.1.6]
c. 22 Dec 1678
3
Elizabeth Ann Bowers
[1.10.2]
b. 8 Dec 1657 d. Bef 11 Feb 1724
3
Mary Bowers
[1.10.3]
b. 16 Sep 1660 d. 16 Dec 1669
3
Henry Bowers
[1.10.4]
b. 2 Jun 1665 d. 16 Oct 1690
3
Anna Bowers
[1.10.5]
b. 1670
3
Bathsheba Bowers
[1.10.6]
b. 4 Jun 1671 d. Abt 1718
3
Johnathan Bowers
[1.10.7]
b. 11 Aug 1673 d. 1750
2
Alice Dunster
[1.11]
b. 1629