Home Page
|
What's New
|
Photos
|
Histories
|
Headstones
|
Reports
|
Surnames
Search
First Name:
Last Name:
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Suomalainen
Svenska
Elizabeth Noyes
1610 - Bef 1698 (< 87 years)
Submit Photo / Document
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Submit Photo / Doc
Worksheet
Family
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Elizabeth Noyes
[1]
b. 1610 d. Bef 1698
Thomas Hapgood
b. 1601 d. 1666
2
John Hapgood
[1.1]
b. 2 Apr 1632
Joan Blake
b. Abt 1636
3
John Hapgood
[1.1.1]
b. 2 Feb 1664
Elizabeth Dear
4
William Hopgood
[1.1.1.1]
b. 27 Jul 1702
4
Joan Hopgood
[1.1.1.2]
b. 14 May 1705
Robert White
b. 17 Jun 1700
5
William White
[1.1.1.2.1]
b. 1730
Elizabeth Futcher
b. 5 Mar 1741 d. 1775
6
William White
[1.1.1.2.1.1]
c. 9 Feb 1759 d. 1803
Elizabeth Greenwood
b. 1763 d. 26 Jul 1844
7
James White
[1.1.1.2.1.1.1]
b. 8 Aug 1787 d. 2 Oct 1867
Charlotte Newington
b. 22 Nov 1789 d. 14 Aug 1820
8
Mary Ann White
[1.1.1.2.1.1.1.1]
b. 9 May 1815 d. Abt 1845
William Pay
b. 1811
9
Reuben Pay
[1.1.1.2.1.1.1.1.1]
b. 1838
9
Ann Pay
[1.1.1.2.1.1.1.1.2]
b. 1839
9
Robert Pay
[1.1.1.2.1.1.1.1.3]
b. 1841 d. 16 Jun 1841
9
John Pay
[1.1.1.2.1.1.1.1.4]
b. Abt 1842
9
David Pay
[1.1.1.2.1.1.1.1.5]
b. Abt 1845
9
Elizabeth Pay
[1.1.1.2.1.1.1.1.6]
b. Jul 1847 d. 1908
9
Joseph Pay
[1.1.1.2.1.1.1.1.7]
b. 1850
9
Rose Pay
[1.1.1.2.1.1.1.1.8]
b. Abt 1854
9
Mercey Pay
[1.1.1.2.1.1.1.1.9]
b. Sep 1854
9
Rhoda Pay
[1.1.1.2.1.1.1.1.10]
b. 1856 d. 27 Jan 1934
8
George White
[1.1.1.2.1.1.1.2]
b. 20 Jul 1817 d. 26 Jan 1861
8
James White
[1.1.1.2.1.1.1.3]
b. 3 Apr 1818 d. 12 Feb 1869
Martha Chessel
b. 13 Jan 1825 d. 18 Jan 1870
9
Elizabeth Chessel White
[1.1.1.2.1.1.1.3.1]
b. 17 May 1847 d. 23 Jun 1868
9
Charlotte Chessel White
[1.1.1.2.1.1.1.3.2]
b. 22 Sep 1848 d. 21 Aug 1926
Henry Issac Mills
b. 15 Aug 1850 d. 15 Oct 1872
10
Henry Isaac Mills
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.1]
b. 15 May 1870 d. 19 Feb 1949
Mary Lehmann
b. 24 Mar 1876 d. 6 Jul 1961
11
Irene Mills
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.1.1]
b. 7 Jan 1894 d. 2 Jul 1899
11
Gladys Mills
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.1.2]
b. 19 Jun 1895 d. 22 Jun 1998
Daniel Thomas Williams
b. 27 Dec 1892 d. 7 Sep 1971
12
Keith Daniel Williams
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.1.2.1]
b. 25 Jan 1917 d. 18 Apr 1997
12
Hortella Williams
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.1.2.2]
b. 6 Jul 1913 d. 4 May 2002
12
Hortense Williams
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.1.2.3]
b. 6 Jul 1913 d. 24 Apr 2005
11
Ivan Varsel Mills
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.1.3]
b. 24 Apr 1897 d. 17 Jul 1960
+
Frances Hoffman
b. 22 Dec 1876 d. 19 Aug 1931
+
Violet Lois Warden
b. 22 Sep 1898 d. Feb 1987
11
Frederick Rex Mills
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.1.4]
b. 29 Jun 1900 d. 2 Oct 1942
Lettie Lyle Rose
b. 11 Jul 1901 d. 3 Nov 1980
12
Rex Rosell Mills
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.1.4.1]
b. 3 Nov 1924 d. 19 Mar 2006
12
Flora Lyle Mills
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.1.4.2]
b. 28 Aug 1926 d. 13 Sep 2006
12
Joseph DeVerl Mills
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.1.4.3]
b. 1 Feb 1932 d. 16 Apr 2002
11
Marion Mills
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.1.5]
b. 15 Apr 1902 d. 12 Jul 1988
+
James Harold Robertson
b. 1898
+
Ernest Linton Crowton
b. 3 Jul 1899 d. 6 Nov 1986
11
Lowell LeVern Mills
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.1.6]
b. 5 Jul 1904 d. 11 Nov 1960
11
Milbourne Lehman Mills
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.1.7]
b. 13 Nov 1908 d. 3 Oct 1975
Ida Marguerite Hess
b. 16 Apr 1911 d. 30 Sep 1975
12
Donna Lou Mills
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.1.7.1]
b. 8 Sep 1929 d. 2000 [
=>
]
12
Maralene Mills
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.1.7.2]
b. 6 Apr 1931 d. 8 Jan 2006
11
Alene Mills
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.1.8]
b. 25 Jul 1910 d. 9 Jul 1994
+
Bernard Harten Madsen
b. 28 Feb 1906 d. 23 May 1966
+
Fred Parsons
b. Abt 1913 d. Abt 1995
11
Paul Henry Mills
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.1.9]
b. 11 Sep 1917 d. 4 May 1989
10
Charlotte Elizabeth Mills
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.2]
b. 6 Sep 1872 d. 3 Mar 1951
John William Jones
b. 10 Jun 1851 d. 31 Mar 1931
11
Alvin Eugene Jones
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.2.1]
b. 31 Jan 1891 d. 1 Apr 1942
+
Pearl Sarah Triplett
b. 16 Oct 1896 d. 27 Nov 1960
Phebe Wise
b. 26 Jun 1895 d. 27 Jan 1941
12
Alvin Jones
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.2.1.1]
b. 20 May 1920 d. 24 May 1920
12
Thelma Ruth Jones
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.2.1.2]
b. 21 Apr 1922 d. 22 Feb 1984 [
=>
]
12
Helen Jones
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.2.1.3]
b. 7 Dec 1924 d. 19 Nov 2009
11
David Arthur Jones
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.2.2]
b. 1 Jul 1894 d. 23 Jan 1974
+
Lillian Pearl McAfee
b. 3 Sep 1901 d. 6 May 1982
11
Doris Corinda Jones
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.2.3]
b. 20 Mar 1907 d. 23 Apr 1987
Charles Alfred Kramer
b. 1903 d. Jan 1979
12
Maxine Doris Beveridge
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.2.3.1]
b. 21 Jun 1926 d. 19 Jun 2011 [
=>
]
+
James Albert Beveridge
b. 8 Jun 1905 d. 31 Mar 1996
+
Martin Luther Gilmore
b. 5 Sep 1907 d. 1 Jan 1981
David William Horsley
b. 28 Mar 1850 d. 13 Apr 1930
10
Rose Ann Horsley
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.3]
b. 22 Nov 1874 d. 24 Oct 1875
10
David William Horsley
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.4]
b. 17 Sep 1876 d. 17 Aug 1953
Bertha Elizabeth Brown
b. 4 Mar 1878 d. 7 Mar 1906
11
Rulon David Horsley
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.4.1]
b. 5 Jul 1902 d. 6 Dec 1964
Patricia Brown Hayes
b. 14 Dec 1907 d. 23 Mar 2005
12
Pauline Claire Horsley
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.4.1.1]
b. 7 Dec 1934 d. 8 Jun 2009
Inga Eliza Hansen
b. 31 Mar 1880 d. 30 Nov 1951
11
Glen William Horsley
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.4.2]
b. 23 Jan 1908 d. 8 Feb 1992
Edna Senior
b. 31 Jul 1907 d. 31 Aug 1995
12
Corinne Joyce Horsley
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.4.2.1]
b. 5 Oct 1929 d. 28 Apr 2004 [
=>
]
+
Berthe Claire Maillet
b. 20 Jun 1911 d. 28 Dec 1980
11
Frank Lester Horsley
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.4.3]
b. 9 Nov 1909 d. 11 Oct 1980
11
Myla Inga Horsley
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.4.4]
b. 8 Nov 1911 d. 3 Sep 1938
Jasper Leroy Barr
b. 5 Aug 1907 d. 28 Dec 1978
12
Jasper Leroy Barr, Jr
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.4.4.1]
b. 28 Jun 1931 d. 5 Jan 2001
11
Louis Elmo Horsley
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.4.5]
b. 1 Oct 1913 d. 27 Oct 1949
+
Florence Margaret Mourzukos
b. 25 Dec 1911 d. 25 Oct 1974
11
Grace Arlene Horsley
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.4.6]
b. 2 Apr 1917 d. 16 Sep 2006
+
Victor DuWayne Royce
b. 18 Apr 1913 d. 12 Dec 1997
11
Bertha Irene Horsley
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.4.7]
b. 16 Aug 1919 d. 28 Apr 1999
+
Joseph Clayton Romel
11
Ray Earl Horsley
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.4.8]
b. 18 Dec 1920 d. 20 Jan 1921
11
May Horsley
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.4.9]
b. 18 Dec 1920 d. 18 Dec 1920
+
Ella Estella Barton
b. 3 Nov 1879 d. 21 May 1961
10
Susetta Horsley
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.5]
b. 20 Feb 1879 d. 26 Dec 1962
Levi Bowers
b. 27 Aug 1882 d. 2 Apr 1977
11
Ivan Levi Bowers
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.5.1]
b. 13 Jul 1911 d. 23 Dec 1977
+
Pearl Lucile Sollis
b. 12 Sep 1913 d. 26 Jan 1995
11
Frances Charlotte Bowers
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.5.2]
b. 23 Dec 1913 d. 4 Apr 2003
+
Richard Karl Iba
b. 28 Mar 1913 d. 8 Feb 1985
11
Marjorie Horsley Bowers
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.5.3]
b. 12 Aug 1916 d. 26 Apr 2011
Arthur William Salt
b. 15 May 1915 d. 8 Nov 1993
12
Ronald Arthur Salt
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.5.3.1]
b. 25 Jun 1938 d. 8 Aug 2013
11
Violet Bowers
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.5.4]
b. 17 Aug 1919 d. 19 Sep 1925
10
Charles Albert Horsely
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.6]
b. 17 Dec 1881 d. 1 Mar 1927
Fannie Alice Rudd
b. 17 Jan 1885 d. 20 Mar 1978
11
Kenneth Albert Horsley
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.6.1]
b. 1 Jan 1908 d. 3 Nov 1995
+
Della Margaret Bertelson
b. 24 Apr 1910 d. 21 Jan 1945
+
Fern Ramona Garfield
b. 2 Feb 1918 d. 11 Mar 2012
11
Vivian Alice Horsley
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.6.2]
b. 5 Aug 1910 d. 5 Jul 1911
11
Grant B Horsley
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.6.3]
b. 4 Jul 1912 d. 9 Jan 1999
+
Zora Louise Richins
b. 7 Mar 1914 d. 1 Oct 1970
11
Loraine Marie Horsley
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.6.4]
b. 12 Aug 1918 d. 29 Jan 2002
+
Melvin Willis Garfield
b. 24 Dec 1919 d. 17 May 1988
10
Arthur Horsley
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.7]
b. 4 Feb 1885 d. 17 Feb 1885
10
Ernest Horsley
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.8]
b. 4 Feb 1885 d. 24 May 1977
Agnes Amelia Williamson
b. 6 Aug 1892 d. 17 Jun 1978
11
Bernice Alene Horsley
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.8.1]
b. 7 Feb 1917 d. 9 Jan 2015
Lowell P Hicks
12
Kay Hicks
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.8.1.1]
12
Jean Hicks
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.8.1.2]
12
Roger Hicks
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.8.1.3]
12
Teresa Hicks
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.8.1.4]
12
Ron Hicks
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.8.1.5]
11
Ernest Raymond Horsley
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.8.2]
b. 19 Jul 1919 d. 28 Apr 2015
11
Jean Horsley
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.8.3]
b. 25 Jun 1921 d. 20 Apr 2011
+
Arthur Vernon Smith
b. 5 May 1920 d. 5 Apr 2004
11
Ernest Raymond Horsley
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.8.4]
10
George Robert Horsley
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.9]
b. 18 Sep 1887 d. 13 Dec 1923
Genevieve Whittingham Garbett
b. 18 Sep 1891 d. 23 Aug 1965
11
Lucille Genevive Horsley
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.9.1]
b. 23 Dec 1910 bur. 29 Nov 1986
Charles Therus Whittaker
b. 17 Oct 1909 d. 25 Aug 1955
12
Evelyn Vernice Whittaker
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.9.1.1]
b. 2 Mar 1932 d. 14 Nov 1985
12
Charles Kendall Whittaker
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.9.1.2]
b. 29 Jan 1936 d. 26 Aug 2012
12
Joyce Lucille Whittaker
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.9.1.3]
b. 8 Aug 1941 d. 26 Mar 1982 [
=>
]
11
Evelyn Martha Horsley
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.9.2]
b. 3 Sep 1912 d. 21 Dec 2003
+
Voscoe Leon Burnham
b. 22 Jan 1905 d. 18 May 1983
10
Joseph LeRoy Horsley
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.10]
b. 18 Jul 1893 d. 26 May 1976
Flora Kohler
b. 18 Apr 1902 d. 30 Aug 1998
11
Kathleen Horsley
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.10.1]
b. 2 Nov 1923 d. 3 Dec 2011
Leland Wayne Redd
b. 28 Apr 1920 d. 18 Sep 2009
12
Suzanne Redd
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.10.1.1]
b. 26 Feb 1950 d. 19 Jan 2008
12
Patrice Redd
[1.1.1.2.1.1.1.3.2.10.1.2]
b. 28 Nov 1959 d. 29 Nov 1959
9
Charles William Chessel White
[1.1.1.2.1.1.1.3.3]
b. 20 Feb 1851 d. 25 Aug 1924
Edith Carter
b. 24 May 1854 d. 14 Jun 1922
10
Charles William Chessel White
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.1]
b. 9 Oct 1876 d. 13 Jul 1879
10
Frank White
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.2]
b. 7 Nov 1879 d. 7 Jan 1967
Sarah Grace Barber
b. 16 Apr 1883 d. 23 Aug 1966
11
Thomas Frank White
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.2.1]
b. 23 Jun 1910 d. 3 Jun 1995
Maxine Mercer
b. 4 Dec 1911 d. 24 Feb 1998
12
Barbara White
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.2.1.1]
b. 10 Aug 1937 d. 28 Sep 2017
11
Charles Dennis White
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.2.2]
b. 27 Mar 1912 d. 24 Nov 1992
+
June Rampton
b. 27 Apr 1915 d. 14 Mar 1986
11
Elmer Barber White
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.2.3]
b. 31 Jan 1914 d. 31 Mar 2001
Thelma Catherine Lund
b. 23 Oct 1916 d. 6 Nov 2010
12
Living
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.2.3.1]
12
Living
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.2.3.2]
12
Living
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.2.3.3]
11
Lovell White
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.2.4]
b. 28 Aug 1916 d. 1 Sep 1916
10
William Carter White
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.3]
b. 29 Sep 1881 d. 30 Sep 1964
Clara Mansanetta Brown
b. 8 Sep 1888 d. 10 Feb 1938
11
Edith Beatrice White
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.3.1]
b. 6 Mar 1911 d. Jul 1985
James Clinton Hebb
b. 15 Oct 1907 d. Apr 1970
12
Jean Cecilia Hebb
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.3.1.1]
b. 13 Jun 1929 d. 15 Sep 2006
11
Loretta B White
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.3.2]
b. 6 Mar 1911
11
Clara Manetta White
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.3.3]
b. 13 Sep 1917 d. Jun 1992
+
Robert Louis Scholz
11
Living
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.3.4]
11
Living
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.3.5]
+
Shirley Ann Harvey
10
James White
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.4]
b. 18 Mar 1884 d. 2 Jul 1972
Ellen Elizabet Landeen
b. 18 Jun 1891 d. 10 Dec 1918
11
James White, Jr
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.4.1]
b. 7 Jun 1910 d. 8 Jun 1997
Margot Arvilla Lund
b. 23 Sep 1910 d. 21 Jul 2005
12
Living
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.4.1.1]
[
=>
]
12
Living
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.4.1.2]
[
=>
]
11
Guy Landeen White
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.4.2]
b. 23 Apr 1912 d. 15 Jun 2000
+
Marie Elizabeth Burns
b. 25 Dec 1911 d. 27 Jul 1959
+
Mary Torres
b. 13 Apr 1925 d. 5 Nov 2016
+
Betty
+
Thelma Merrel Stimpson
b. 2 Jan 1907 d. 21 Nov 1974
Florence Ruby Forbes
b. 11 Dec 1893 d. 9 Apr 1967
11
Nancy Ellen White
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.4.3]
b. 14 May 1921 d. 11 Feb 1986
+
Lex J Welling
b. 4 Aug 1920 d. 1 Oct 1962
+
John Richard Nielsen
b. 13 Feb 1918 d. 21 Aug 2011
William Martin Shirley
b. 7 May 1907 d. 9 Dec 1982
12
Living
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.4.3.1]
12
Living
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.4.3.2]
11
Living
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.4.4]
Living
12
Living
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.4.4.1]
12
Gregory Gaffney
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.4.4.2]
12
Living
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.4.4.3]
+
William Orlandos
10
Edith C White
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.5]
b. 3 Nov 1886 d. 17 Sep 1965
Orson Nephi Bangerter
b. 6 Aug 1884 d. 25 Feb 1946
11
Orson Nephi Bangerter, Jr
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.5.1]
b. 3 Dec 1907 d. 23 Sep 1977
Rosabelle Hatch
b. 25 Jun 1906 d. 13 May 1997
12
Daughter Bangerter
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.5.1.1]
b. 27 Nov 1928 d. 27 Nov 1928
12
Marlon Dale Bangerter
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.5.1.2]
b. 23 Dec 1931 d. 15 Jan 2018
11
George White Bangerter
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.5.2]
b. 11 Jul 1909 d. 5 Apr 1996
+
Vera Betty Jones
b. 28 Jun 1907 d. 27 Dec 1993
11
Rulon David Bangerter
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.5.3]
b. 29 Sep 1910 d. 29 Aug 1999
Wanda Howell
b. 30 Oct 1910 d. 21 Mar 1989
12
Son Bangerter
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.5.3.1]
b. 12 Jun 1939 d. 12 Jun 1939
+
Beverlee Irene Bowen
b. 27 Aug 1911 d. 5 Feb 2001
11
Glen White Bangerter
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.5.4]
b. 22 Mar 1912 d. 11 Aug 1999
Pearl Hillert Nakken
b. 6 Nov 1916 d. 10 Nov 1991
12
Dixie Ann Nakken
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.5.4.1]
b. 25 Feb 1938 d. 11 Mar 2020
11
Rodney White Bangerter
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.5.5]
b. 15 Feb 1914 d. 28 Aug 1999
Claire Bella Hickson
b. 2 May 1916 d. 1 Feb 2003
12
Living
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.5.5.1]
12
Susan Frances Bangerter
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.5.5.2]
b. 9 Jul 1945 d. 27 Jun 1997
11
Florence Bangerter
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.5.6]
b. 16 Feb 1916 d. 1 Mar 1966
David Morris Tacher
b. 1 Aug 1914 d. 5 Jan 1987
12
Sharon Elisabeth Tacher
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.5.6.1]
b. 7 Dec 1941 d. 1 Mar 1945
12
Vicki Lynn Tacher
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.5.6.2]
b. 29 Mar 1948 d. 7 Jun 1956
11
Charles White Bangerter
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.5.7]
b. 31 Jul 1918 d. 9 Apr 1999
Fern Elda Wright
b. 5 Jul 1921 d. 31 May 2010
12
Charles Reed Bangerter
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.5.7.1]
b. 23 Apr 1942 d. 17 Feb 2017
12
Hal Dee Bangerter
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.5.7.2]
b. 23 Mar 1956 d. 10 Sep 2005
+
Betty Lee Johnson
11
Edith Bangerter
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.5.8]
b. 12 Nov 1919 d. 6 Jun 1920
11
Donald White Bangerter
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.5.9]
b. 20 Jun 1921 d. 31 May 2006
JenaVee Moffitt
b. 9 Jan 1922 d. 4 Mar 2013
12
Donald Richard Bangerter
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.5.9.1]
b. 17 Feb 1943 d. 2006
12
Rick Bangerter
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.5.9.2]
12
Val Bangerter
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.5.9.3]
12
Shawna Bangerter
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.5.9.4]
12
Sherrie Bangerter
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.5.9.5]
12
Wanda Bangerter
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.5.9.6]
11
Dean Ralph Bangerter
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.5.10]
b. 2 Dec 1923 d. 6 Apr 1999
+
Thora Beth Clawson
b. 23 Jul 1923 d. 28 Apr 1992
11
Floyd White Bangerter
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.5.11]
b. 5 Apr 1927 d. 24 Feb 2004
Elaine Boswell
12
Jimmie Lee Bangerter
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.5.11.1]
b. 1 Sep 1946 d. 6 Jan 2006 [
=>
]
+
Doris Edwards
b. 20 Nov 1927 d. 13 Jan 2014
+
Lorna Estelle Snider
b. 17 Dec 1928 d. 23 Jun 2013
11
Carter White Bangerter
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.5.12]
b. 25 Jan 1930 d. 7 May 2005
+
Betty Ernst
+
Shirley Jean Field Walpole
10
George White
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.6]
b. 3 Nov 1886 d. 18 Aug 1930
Florence Jane Holbrook
b. 29 Jul 1889 d. 25 Nov 1966
11
Marco White
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.6.1]
b. 7 Jun 1914 d. 29 Sep 1988
+
Clarence Eugene Hudepohl
b. 16 Jul 1921 d. 15 Feb 2003
11
Helen Faye White
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.6.2]
b. 26 Sep 1916 d. 21 Jul 2007
Harold Barber Wilcox
b. 11 Jun 1914 d. 27 Dec 2006
12
Mary Sue Wilcox
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.6.2.1]
b. 12 Feb 1950 d. 5 Jul 2013
10
Sidney Carter White
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.7]
b. 3 Feb 1889 d. 14 Dec 1918
Ida Josephine Holmes
b. 14 Dec 1890 d. 27 Nov 1965
11
Mildred Ida White
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.7.1]
b. 11 Feb 1915 d. 28 Nov 1942
+
Arthur Edward Price
b. 3 Aug 1913 d. 4 Jul 1999
11
Clifford Sidney White
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.7.2]
b. 16 Aug 1916 d. 16 Mar 2012
+
Viola Barton Devenberg
b. 28 Jun 1923 d. 31 Mar 2012
10
Arthur Edward White
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.8]
b. 13 Aug 1891 d. 27 Oct 1971
Catherine Wanda Henderson
b. 29 Aug 1895 d. 30 Nov 1986
11
Arthur Samuel White
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.8.1]
b. 11 Aug 1916 d. 13 May 1957
Living
12
Arthur Robert White
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.8.1.1]
b. 7 Jul 1951 d. 11 Nov 2002
11
Charles William White
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.8.2]
b. 11 Apr 1920 d. 7 Dec 1941
Mary Myrlene Richins
b. 27 Jun 1919 d. 17 Dec 1978
12
Living
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.8.2.1]
11
Douglas Dean White
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.8.3]
b. 16 Mar 1923 d. 26 Nov 2011
Larue Harrison
b. 18 Oct 1926 d. 29 Dec 1986
12
Claudine White
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.8.3.1]
b. 1 Oct 1948 d. 4 Nov 2013
10
Clyde Carter White
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.9]
b. 8 May 1894 d. 21 Feb 1979
Amelia Hepworth
b. 6 Mar 1900 d. 7 Oct 1981
11
Amelia White
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.9.1]
b. 18 Nov 1919 d. 25 Nov 1919
11
Clyde Edmund White
[1.1.1.2.1.1.1.3.3.9.2]
b. 16 Apr 1921 d. 13 Jul 2004
+
Orlene Nicholes
b. 29 Apr 1920 d. 1 Nov 2009
9
George Chessel White
[1.1.1.2.1.1.1.3.4]
b. 7 Feb 1854 d. 6 Feb 1922
Elizabeth Anne Mant
b. 1858 d. 22 May 1913
10
Mary Elizabeth White
[1.1.1.2.1.1.1.3.4.1]
b. 23 Feb 1880
10
George James White
[1.1.1.2.1.1.1.3.4.2]
b. 2 Jan 1882 d. 3 Aug 1898
10
Alice Susan White
[1.1.1.2.1.1.1.3.4.3]
b. 22 Jul 1883
10
Amy Clara White
[1.1.1.2.1.1.1.3.4.4]
b. 7 Oct 1884 d. 16 Aug 1886
10
Frank Charles White
[1.1.1.2.1.1.1.3.4.5]
b. 22 Jul 1886 d. 7 Sep 1889
10
Joseph Mant White
[1.1.1.2.1.1.1.3.4.6]
b. 25 Jan 1888
10
Emma Martha White
[1.1.1.2.1.1.1.3.4.7]
b. 14 Aug 1896 d. 16 Aug 1896
10
Arthur Gordon White
[1.1.1.2.1.1.1.3.4.8]
b. 13 Sep 1897 d. 17 Oct 1898
9
Susan Chessel White
[1.1.1.2.1.1.1.3.5]
b. 11 Jul 1857 d. 30 Oct 1942
John Taylor Harman
b. 6 Apr 1846 d. 2 Mar 1926
10
John Dewey Harman
[1.1.1.2.1.1.1.3.5.1]
b. 4 May 1898 d. 20 Nov 1974
Vera Emery
b. 27 Dec 1898 d. 22 Mar 1967
11
Irene Harman
[1.1.1.2.1.1.1.3.5.1.1]
b. 10 Sep 1918 d. 1 Jan 2006
Ernest Franklin Murdock
b. 21 Feb 1911 d. 6 Mar 1972
12
Warren Harman Murdock
[1.1.1.2.1.1.1.3.5.1.1.1]
b. 29 Sep 1939 d. 28 Aug 2006
12
Marlene Sue Murdock
[1.1.1.2.1.1.1.3.5.1.1.2]
b. 30 Apr 1946 d. 15 Aug 1952
11
George Emery Harman
[1.1.1.2.1.1.1.3.5.1.2]
b. 2 Oct 1922 d. 26 Nov 2005
9
Alice Mary White
[1.1.1.2.1.1.1.3.6]
b. 13 May 1860 d. 25 May 1909
Reuben Andrew Robinson Blaisdell
b. 24 Feb 1847 d. 1 Oct 1922
10
Rueben Andrew Blaisdell
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.1]
b. 2 Mar 1877 d. 11 May 1941
Matilda Delila Stephens
b. 3 Jun 1884 d. 13 Jun 1949
11
Alice Lavon Blaisdell
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.1.1]
b. 28 Dec 1902 d. 18 Oct 1997
Gerald Lyle Pierson
b. 13 Oct 1895 d. 26 Mar 1965
12
Lila Jean Pierson
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.1.1.1]
b. 11 Nov 1921 d. 21 Apr 2008
12
Howard Andrew Pierson
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.1.1.2]
b. 20 Jan 1935 d. 8 May 2013
11
Una Delila Blaisdell
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.1.2]
b. 3 Aug 1905 d. 31 Oct 1983
+
Russell William Watson
b. 30 Mar 1903 d. 27 Feb 1962
11
Reuben Verrell Blaisdell
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.1.3]
b. 22 Jan 1907 d. 30 Jun 1985
Living
12
Living
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.1.3.1]
11
Florence Adelia Blaisdell
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.1.4]
b. 4 Dec 1908 d. 24 May 1991
Clarence Terry Bridges
b. 9 Mar 1907 d. 11 Apr 1947
12
Ronald Terry Bridges
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.1.4.1]
b. 4 Sep 1932 d. 15 Nov 1989 [
=>
]
12
Kenneth LeRoy Bridges
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.1.4.2]
b. 12 Jul 1934 d. 22 Jan 1943
12
Living
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.1.4.3]
[
=>
]
+
Cecil Emery Mellinger
b. 11 Nov 1903 d. 1 Nov 1979
11
James Alden Blaisdell
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.1.5]
b. 27 Sep 1910 d. 5 May 2005
Dorothy Evelyn Sparks
b. 7 Jan 1910 d. 31 Dec 1989
12
Dorothy Marcia Blaisdell
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.1.5.1]
b. 4 Oct 1937 d. 15 Dec 2003
11
Leah May Blaisdell
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.1.6]
b. 19 May 1912 d. 8 Nov 1979
Willard Harold Collins
b. 31 Mar 1917 d. 8 Nov 1979
12
Norman Willard Collins
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.1.6.1]
b. 26 Nov 1940 d. 9 Jan 1941
11
Leo Ray Blaisdell
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.1.7]
b. 20 May 1912 d. 14 Nov 1954
Johanna Moser
b. 4 Jun 1918 d. 28 Feb 2011
12
Patricia Joan Blaisdell
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.1.7.1]
b. 25 May 1937 d. 20 Apr 2005
12
Kyle Leo Blaisdell
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.1.7.2]
b. 27 Mar 1939 d. 28 Nov 1994
10
Alice Tabasha Blaisdell
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.2]
b. 14 Jul 1879 d. 5 Oct 1967
+
Henry Charles Strange
b. 1873
William Lorenzo Yearsley
b. 28 May 1879 d. 19 Sep 1971
11
Leona Yearsley
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.2.1]
b. 2 Feb 1904 d. 29 Feb 1992
Elmer Ellsworth Juckett
b. 27 May 1904 d. 6 Jan 1951
12
Nelita Marie Juckett
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.2.1.1]
b. 4 Aug 1924 d. 14 Oct 1999
12
Bonda Lue Juckett
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.2.1.2]
b. 30 Dec 1925 d. 1 Oct 2008 [
=>
]
12
Nola Jean Juckett
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.2.1.3]
b. 27 Jul 1927 d. 24 Aug 2013
11
Ruland Roy Yearsley
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.2.2]
b. 8 May 1906 d. 15 Oct 2003
Esther Lerenia Hardcastle
b. 8 Apr 1909 d. 26 Nov 2000
12
Faye Alyce Yearsley
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.2.2.1]
b. 8 Jan 1948 d. 1 May 1981
11
Glen Blaisdell Yearsley
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.2.3]
b. 7 Jan 1908 d. 10 Jun 1960
Thora Hansen
b. 12 Nov 1909 d. 19 Jul 1994
12
James Leon Yearsley
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.2.3.1]
b. 8 Nov 1937 d. Feb 1988
Alice Rose Williams
b. 16 Apr 1911 d. 5 Oct 1984
12
Billy Kyle Yearsley
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.2.3.2]
b. 19 Dec 1932 d. 12 Jun 1999
11
Ray Lorenzo Yearsley
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.2.4]
b. 3 Jan 1910 d. 22 May 2002
+
Rosa Jakeman
b. 5 Sep 1916 d. 12 Dec 1939
+
Blanche Mae Potter
b. 19 Nov 1925 d. 12 Nov 1999
10
James William Blaisdell
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.3]
b. 18 Nov 1881 d. 20 Dec 1943
Ann Iona Bingham
b. 24 Aug 1887 d. 2 Jun 1932
11
Lapreal Blaisdell
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.3.1]
b. 20 Apr 1913 d. 28 Dec 2001
11
Waldo J Blaisdell
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.3.2]
b. 8 Oct 1915 d. 22 Aug 2004
+
Lois Lennon
b. 20 Feb 1924 d. 11 Oct 2011
11
James Pershing Blaisdell
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.3.3]
b. 29 Jun 1918 d. 4 Jun 2009
Wanda Bindrup
b. 17 Apr 1921 d. 17 Apr 2010
12
Don Allen Blaisdell
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.3.3.1]
b. 25 May 1943 d. 27 Feb 1945
12
Joann Blaisdell
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.3.3.2]
b. 17 Oct 1946 d. 25 Sep 2011
12
Living
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.3.3.3]
11
Orlan E Blaisdell
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.3.4]
b. 16 Feb 1927 d. 14 Apr 1970
10
John Edward Blaisdell
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.4]
b. 11 May 1884 d. 28 Apr 1976
Florence Julia Barber
b. 15 Jul 1885 d. 23 Mar 1952
11
James Edward Blaisdell
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.4.1]
b. 7 Sep 1910 d. 6 Feb 1912
11
Julia Thora Blaisdell
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.4.2]
b. 23 Jul 1912 d. 17 Aug 2005
+
Albert Rex Jensen
b. 6 Sep 1910 d. 10 Mar 1997
11
Nolan Thomas Blaisdell
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.4.3]
b. 4 Jan 1914 d. 13 Nov 2004
Letitia Rae Gibbs
b. 30 Mar 1919 d. 6 Jul 1970
12
Nolan Allen Blaisdell
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.4.3.1]
b. 17 May 1943 d. 3 Nov 2012
+
Iris Jane Ipsen
b. 31 Oct 1926 d. 12 Dec 2007
11
John Dale Blaisdell
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.4.4]
b. 21 Oct 1915 d. 7 Sep 2005
+
Annie Lorraine Daniels
b. 11 Jan 1918 d. 1 Sep 2004
11
Theron Levi Blaisdell
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.4.5]
b. 8 Feb 1917 d. 3 Dec 2007
11
Alice Blaisdell
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.4.6]
b. 28 Nov 1918 d. 12 May 2007
Chester L Edwards
b. 22 Dec 1920 d. 30 Jan 1973
12
Chester John Edwards
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.4.6.1]
b. 13 Feb 1941 d. 24 Jun 1994
11
Lorraine Blaisdell
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.4.7]
b. 1 Feb 1921 d. 9 Dec 2009
Lorenzo Dives
b. 17 Jan 1918 d. 21 Apr 2001
12
Connie Dives
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.4.7.1]
b. 1 Mar 1944 d. 23 Apr 1991
11
Reed R Blaisdell
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.4.8]
b. 8 Nov 1922 d. 5 Apr 2012
+
Shelba Ann Harris
b. 21 Sep 1924 d. 16 Aug 1987
11
Kenneth Blaisdell
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.4.9]
b. 10 Jul 1925 d. 26 Dec 1993
+
Myrtle Rebecca Cutler
b. 5 Jan 1888 d. 29 Oct 1973
10
Gertrude Blaisdell
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.5]
b. 10 Nov 1886 d. 9 Jan 1973
Francis Marion Hess
b. 30 Dec 1887
11
Lowell Wayne Hess
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.5.1]
b. 24 Feb 1910 d. 28 Mar 1983
11
Russell William Hess
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.5.2]
b. 15 Jun 1911 d. 21 Aug 2001
11
Norvel Hess
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.5.3]
b. 12 Jan 1915 d. 28 Jul 1993
11
Anona Hess
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.5.4]
b. 1 Nov 1916 d. 17 May 1988
11
Ilean Call
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.5.5]
b. 10 Jun 1921 d. 23 Apr 2012
Charles Edward Call
b. 1 Jan 1882 d. 2 Feb 1954
11
Ilean Call
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.5.6]
b. 10 Jun 1921 d. 23 Apr 2012
Evan Jones
b. 21 Oct 1884 d. 26 Feb 1934
11
Ives Evan Jones
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.5.7]
b. 17 Mar 1924 d. 12 Apr 2008
11
Carma Jean Jones
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.5.8]
b. 14 Oct 1927 d. 14 Nov 1989
+
John Bruce Gunter
b. 3 Nov 1924 d. Jul 1990
Melmberg
12
Living
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.5.8.1]
10
Martha Blaisdell
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.6]
b. 10 Jul 1889 d. 24 Jul 1977
Edward Gleed Williams
b. 9 Oct 1886 d. 30 May 1950
11
Faye Williams
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.6.1]
b. 15 Mar 1912 d. 10 Jan 2013
+
John Earl Caldwell
b. 15 May 1911 d. 12 Feb 1984
11
Dee Edward Williams
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.6.2]
b. 21 Jun 1914 d. 2 Jun 2003
+
Pearl Facer
b. 29 Jul 1913 d. 31 Oct 1998
11
Glen Blaisdell Williams
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.6.3]
b. 15 Feb 1918 d. 30 Jan 1998
11
Samuel Claude Williams
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.6.4]
b. 6 Apr 1920 d. 29 Jul 1997
11
Donald Thayne Williams
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.6.5]
b. 30 Oct 1922 d. 1 Nov 2001
11
Percy B Williams
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.6.6]
b. 28 Jul 1929 d. 18 Aug 1987
10
Asynthia Blaisdell
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.7]
b. 2 May 1892 d. 11 Jul 1986
Reuel Stayner
b. 25 Feb 1893 d. 12 Feb 1971
11
Rae Asyntha Stayner
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.7.1]
b. 19 Sep 1914 d. 4 Nov 1986
11
Dorothy Stayner
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.7.2]
b. 16 Mar 1922 d. 30 Sep 1994
+
Lynn P Dillon
b. 14 Oct 1926 d. 13 Feb 1995
10
Ione Blaisdell
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.8]
b. 18 Mar 1897 d. 21 Jul 1937
Golden Leslie Sorenson
b. 8 Dec 1891 d. 5 May 1979
11
Wayne Leslie Sorenson
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.8.1]
b. 21 Aug 1916 d. 26 Aug 2004
+
Lael Ellertson
b. 21 Jul 1918 d. 5 Feb 2010
11
Dorthy Ione Sorenson
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.8.2]
b. 7 Sep 1919 d. 13 Jan 1927
11
Paul Golden Sorensen
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.8.3]
b. 7 Jul 1921 d. 15 Jan 1997
11
Erma Sorensen
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.8.4]
b. 4 Oct 1924 d. 18 Apr 1963
+
Alton Lincoln Luckert
b. 12 Feb 1923 d. 12 Oct 2001
11
Gale Emma Sorenson
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.8.5]
b. 16 Sep 1925 d. 17 Jul 1929
11
Jack Donald Sorenson
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.8.6]
b. 7 Oct 1929 d. 23 Jun 1976
11
Donna Rae Sorensen
[1.1.1.2.1.1.1.3.6.8.7]
b. 19 Aug 1932 d. 11 Jun 1943
Mary Newington
b. Jul 1800 bur. 16 Jan 1871
8
Henry White
[1.1.1.2.1.1.1.4]
b. 18 Jan 1823
8
William White
[1.1.1.2.1.1.1.5]
b. 1826 d. Jul 1871
8
Harriet White
[1.1.1.2.1.1.1.6]
b. 2 Jul 1828
8
Charles White
[1.1.1.2.1.1.1.7]
b. 1831
8
Thomas Richard White
[1.1.1.2.1.1.1.8]
b. 17 Feb 1833 bur. 4 Apr 1869
4
Ann Hopgood
[1.1.1.3]
c. 5 May 1697
3
Elizabeth Hapgood
[1.1.2]
b. Abt 1659
3
Mary Hapgood
[1.1.3]
b. Abt 1661
3
Elinor Hapgood
[1.1.4]
b. Abt 1663
2
Nathaniel Hapgood
[1.2]
b. Bef 1638
2
Thomas Hapgood
[1.3]
b. Bef 1640
2
Shadrack Hapgood
[1.4]
b. Abt 1642 d. 2 Aug 1675
Elizabeth Treadway
b. 3 Aug 1646 d. 18 Sep 1714
3
Nathaniel Hapgood
[1.4.1]
b. 21 Oct 1665 d. 3 Dec 1727
Elizabeth Ward
b. 21 Mar 1672 d. 5 Nov 1748
4
Nathaniel Hapgood
[1.4.1.1]
b. Abt 1696 d. Abt 1746
4
Shadrach Hapgood
[1.4.1.2]
b. Abt 1702 d. 13 May 1768
Elizabeth Wetherbee
b. 21 Apr 1715 d. 30 Nov 1808
5
Mary Mercy Hapgood
[1.4.1.2.1]
b. 26 Jan 1732 d. 23 Oct 1815
5
Elizabeth Hapgood
[1.4.1.2.2]
b. 26 Sep 1734 d. 13 Nov 1803
5
Phineas Hapgood
[1.4.1.2.3]
b. 1737 d. Aug 1737
5
Asa Hapgood
[1.4.1.2.4]
b. 1739 d. 16 Aug 1743
5
Israel Hapgood
[1.4.1.2.5]
b. 1741 d. 2 Mar 1743
5
Sarah Hopgood
[1.4.1.2.6]
b. 16 Jun 1744
John Daby
b. Abt 1724
6
Simon Daby
[1.4.1.2.6.1]
b. 20 Mar 1765 d. 18 Dec 1802
6
Asa Daby
[1.4.1.2.6.2]
b. 3 Feb 1767 d. 10 Aug 1813
6
Mercy Daby
[1.4.1.2.6.3]
b. 11 May 1769
6
Sarah Daby
[1.4.1.2.6.4]
b. 7 Feb 1772
Josiah Stone
b. 1 Apr 1771
7
Josiah Stone
[1.4.1.2.6.4.1]
b. 29 Dec 1797
7
Levi Stone
[1.4.1.2.6.4.2]
b. 5 Sep 1799
7
Ezra Stone
[1.4.1.2.6.4.3]
b. 8 Dec 1801
7
Sarah Stone
[1.4.1.2.6.4.4]
b. 21 Apr 1805 d. 1849
Lucius Augustus Bingham
b. 1 Sep 1804
8
Calvin Bingham
[1.4.1.2.6.4.4.1]
b. 7 Sep 1827 d. 27 May 1883
8
Benjamin Bingham
[1.4.1.2.6.4.4.2]
b. 1829 d. 27 May 1883
8
Augustus Bingham
[1.4.1.2.6.4.4.3]
b. 27 Oct 1831 d. 20 May 1908
8
Levi Perry Bingham
[1.4.1.2.6.4.4.4]
b. 5 Nov 1832 d. 9 Oct 1903
Sarah Ann Elizabeth Lusk
b. 21 Nov 1833 d. 28 Apr 1893
9
Louisa Elizabeth Bingham
[1.4.1.2.6.4.4.4.1]
b. 22 Jun 1853 d. 7 Feb 1935
9
Susan Emaline Bingham
[1.4.1.2.6.4.4.4.2]
b. 16 Jun 1855 d. 26 Mar 1935
9
Perry Calvin Bingham
[1.4.1.2.6.4.4.4.3]
b. 29 Jun 1857 d. 17 Jul 1916
Rachel Elvira Henderson
b. 25 Jan 1858 d. 10 Dec 1907
10
Sarah Elvira Bingham
[1.4.1.2.6.4.4.4.3.1]
b. 10 Dec 1876 d. 11 Jan 1880
10
Louisa Emaline Bingham
[1.4.1.2.6.4.4.4.3.2]
b. 1 Jan 1879 d. 27 Jul 1959
Samuel Marion Lee Jr
b. 22 Nov 1875 d. 9 May 1947
11
Samuel Perry Lee
[1.4.1.2.6.4.4.4.3.2.1]
b. 5 Dec 1896 d. 14 Aug 1978
11
Harold Bingham Lee
[1.4.1.2.6.4.4.4.3.2.2]
b. 28 Mar 1899 d. 26 Dec 1973
Fern Lucinda Tanner
b. 14 Nov 1895 d. 24 Sep 1962
12
Maurine Lee
[1.4.1.2.6.4.4.4.3.2.2.1]
b. 1 Sep 1924 d. 27 Aug 1965
12
Helen Lee
[1.4.1.2.6.4.4.4.3.2.2.2]
b. 25 Nov 1925 d. 19 Apr 2000
+
Freda Johanna Jensen
b. 2 Jul 1897 d. 1 Jul 1981
11
Clyde Bingham Lee
[1.4.1.2.6.4.4.4.3.2.3]
b. 12 Oct 1902 d. 11 Sep 1953
11
Waldo Bingham Lee
[1.4.1.2.6.4.4.4.3.2.4]
b. 24 Nov 1905 d. 14 Feb 1959
11
Stella Bingham Lee
[1.4.1.2.6.4.4.4.3.2.5]
b. 23 Dec 1907 d. 28 Jan 1974
11
Verda Bingham Lee
[1.4.1.2.6.4.4.4.3.2.6]
b. 1 Jul 1910 d. 26 Aug 1991
10
Perry Calvin Bingham
[1.4.1.2.6.4.4.4.3.3]
b. 4 Jan 1882 d. 10 Dec 1894
10
Effie Lucretia Bingham
[1.4.1.2.6.4.4.4.3.4]
b. 28 Dec 1884 d. 21 Oct 1946
10
Mary F Bingham
[1.4.1.2.6.4.4.4.3.5]
b. 29 Dec 1887 bur. Feb 1888
10
Dora Bingham
[1.4.1.2.6.4.4.4.3.6]
b. 29 Nov 1890
10
Zeida Bingham
[1.4.1.2.6.4.4.4.3.7]
b. 1 Jun 1895
9
John Samuel Bingham
[1.4.1.2.6.4.4.4.4]
b. 23 Feb 1860 d. 6 Sep 1927
9
Lucius Augustus Bingham
[1.4.1.2.6.4.4.4.5]
b. 5 Apr 1862 d. 16 Jan 1931
9
Lucy Lucretia Bingham
[1.4.1.2.6.4.4.4.6]
b. 28 Jun 1864 d. 2 Jul 1917
9
Sarah Maria Bingham
[1.4.1.2.6.4.4.4.7]
b. 8 Apr 1867 d. 16 Apr 1936
9
William David Bingham
[1.4.1.2.6.4.4.4.8]
b. 8 Jun 1870 d. 6 Sep 1899
9
Mary Ardella Bingham
[1.4.1.2.6.4.4.4.9]
b. 21 Sep 1874 d. 7 Dec 1915
8
Son Bingham
[1.4.1.2.6.4.4.5]
b. 10 May 1834 d. Abt 1835
8
Mary Emiline Bingham
[1.4.1.2.6.4.4.6]
b. 10 May 1834 d. 1874
8
Prosper Bingham
[1.4.1.2.6.4.4.7]
b. 1840 d. Abt 1845
8
Lucy Bingham
[1.4.1.2.6.4.4.8]
b. 1843
6
Betsey Daby
[1.4.1.2.6.5]
b. 7 Mar 1774
6
John Daby
[1.4.1.2.6.6]
b. 9 Jan 1779 d. 16 May 1789
5
Shadrach Hapgood
[1.4.1.2.7]
b. 1745 d. 20 Jan 1818
5
Oliver Hapgood
[1.4.1.2.8]
b. 1747 d. 7 Oct 1751
5
Lydia Hapgood
[1.4.1.2.9]
b. Abt 1751 d. 16 Dec 1834
4
Deacon Daniel Hapgood
[1.4.1.3]
b. 1706 d. 30 Apr 1791
4
Sarah Hapgood
[1.4.1.4]
b. Abt 1708
3
Mary Habgood
[1.4.2]
b. 2 Nov 1667 d. 13 Jan 1692
3
Thomas Hapgood
[1.4.3]
b. 1 Feb 1669 d. 4 Oct 1764
3
Sarah Hapgood
[1.4.4]
b. 1672 d. Aft 1730
3
Elizabeth Hapgood
[1.4.5]
b. 1674 d. 20 Jul 1689