Home Page
|
What's New
|
Photos
|
Histories
|
Headstones
|
Reports
|
Surnames
Search
First Name:
Last Name:
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Suomalainen
Svenska
Thomas Browne
Abt 1516 - 1590 (~ 74 years)
Submit Photo / Document
Individual
Descendants
Relationship
Timeline
Submit Photo / Doc
Worksheet
Family
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Thomas Browne
[1]
b. Abt 1516 bur. 23 Dec 1590
Joan Sayer
b. 1552 d. 1610
2
Edward Browne
[1.1]
b. 9 Sep 1574 d. 1649
Jane Leids
b. 1580 d. 1605
3
Ann Browne
[1.1.1]
b. 1595 d. 4 Dec 1669
3
Nicholas Browne
[1.1.2]
b. Abt 1588 d. 5 Apr 1673
4
Thomas Browne
[1.1.2.1]
b. 1607 d. 8 Jan 1687
Lynn Marie Endle
b. 1611 d. 2 Jun 1666
5
Sarah Browne
[1.1.2.1.1]
b. 1610 d. 13 Sep 1691
Reverend James Noyes
b. 22 Oct 1608 d. 22 Oct 1656
6
Joseph Noyes
[1.1.2.1.1.1]
b. 15 Oct 1637 d. 16 Nov 1717
Mary Darvell
b. 10 May 1642 d. 24 Sep 1677
7
Joseph Noyes
[1.1.2.1.1.1.1]
b. 16 Aug 1663
7
Sarah Noyes
[1.1.2.1.1.1.2]
b. 28 Sep 1669 d. Sep 1756
7
Rebecca Noyes
[1.1.2.1.1.1.3]
b. 22 Sep 1671 d. 17 Nov 1734
7
Moses Noyes
[1.1.2.1.1.1.4]
b. 9 Sep 1667 d. 19 May 1689
7
Thomas Noyes
[1.1.2.1.1.1.5]
b. 13 Sep 1667 d. 13 Sep 1667
7
Mary Noyes
[1.1.2.1.1.1.6]
b. 22 Jun 1666 d. 11 Jan 1743
7
Lieutenant John Noyes
[1.1.2.1.1.1.7]
b. 9 Mar 1674 d. 15 Apr 1765
6
Reverend James Noyes
[1.1.2.1.1.2]
b. 11 Mar 1640 d. 30 Dec 1719
Dorothy Stanton
b. Abt 1650 d. 19 Jan 1742
7
John Noyes
[1.1.2.1.1.2.1]
b. 13 Jan 1685 d. 17 Sep 1751
7
Joseph Noyes
[1.1.2.1.1.2.2]
b. 16 Oct 1688 d. 14 Jun 1761
7
Moses Noyes
[1.1.2.1.1.2.3]
b. 19 Mar 1692 d. 30 Apr 1692
7
Dorothy Noyes
[1.1.2.1.1.2.4]
b. 20 Jan 1676 d. 6 Dec 1714
7
Anna Noyes
[1.1.2.1.1.2.5]
b. 16 Apr 1682 d. 28 Jun 1694
7
James Noyes
[1.1.2.1.1.2.6]
c. 21 Oct 1677 bur. 1718
7
Thomas Noyes
[1.1.2.1.1.2.7]
b. 15 Aug 1679 d. 26 Jun 1755
6
Reverend Moses Noyes
[1.1.2.1.1.3]
b. 23 Sep 1648 d. 25 Oct 1734
Ruth Pickett
b. 16 Dec 1653 d. 14 Sep 1690
7
Naomi Noyes
[1.1.2.1.1.3.1]
b. Abt 1676 d. 15 Mar 1728
William Comstock
b. 8 Jan 1669 d. 15 Mar 1728
8
John Comstock
[1.1.2.1.1.3.1.1]
b. 9 Aug 1696 d. 28 Mar 1767
Rebecca Bates
b. Abt 1704
9
Phebe Comstock
[1.1.2.1.1.3.1.1.1]
b. 16 Nov 1727
9
Curtis Comstock
[1.1.2.1.1.3.1.1.2]
b. 8 Oct 1729 d. 1772
9
Rebecca Comstock
[1.1.2.1.1.3.1.1.3]
b. 11 Feb 1732
9
Gideon Comstock
[1.1.2.1.1.3.1.1.4]
b. Abt 1736 d. 1746
8
William Comstock
[1.1.2.1.1.3.1.2]
b. 15 Jun 1698 d. 19 Jun 1765
Mary Bates
b. 1 Jul 1711 d. 29 Mar 1743
9
Abigail Comstock
[1.1.2.1.1.3.1.2.1]
c. 27 Apr 1726 d. 1776
9
William Comstock
[1.1.2.1.1.3.1.2.2]
b. 1733 d. 1773
9
Anne Comstock
[1.1.2.1.1.3.1.2.3]
b. Abt 1737
9
Naomi Comstock
[1.1.2.1.1.3.1.2.4]
b. 1739 d. 21 Dec 1831
9
Ruth Comstock
[1.1.2.1.1.3.1.2.5]
b. 18 Apr 1741 d. 18 Apr 1804
8
Abigail Comstock
[1.1.2.1.1.3.1.3]
b. 1700 d. 16 Oct 1773
Joseph Lord
b. 17 Oct 1697 d. 25 Jul 1736
9
Abigail Lord
[1.1.2.1.1.3.1.3.1]
b. 3 Feb 1726 d. 1771
9
Joseph Lord
[1.1.2.1.1.3.1.3.2]
b. 3 Feb 1726 d. 13 Mar 1788
9
Benjamin Lord
[1.1.2.1.1.3.1.3.3]
b. 3 Jan 1728 d. 6 Feb 1805
9
Elijah Lord
[1.1.2.1.1.3.1.3.4]
b. 1 Jan 1730
9
Elizabeth Lord
[1.1.2.1.1.3.1.3.5]
b. 19 Aug 1732 d. 20 Dec 1753
9
Sylvanus Lord
[1.1.2.1.1.3.1.3.6]
b. 21 Aug 1734 d. 29 Nov 1762
9
Captain Daniel Lord
[1.1.2.1.1.3.1.3.7]
b. 1736 d. 21 Sep 1796
8
Ruth Comstock
[1.1.2.1.1.3.1.4]
b. Abt 1702
+
Jonathan Reed
b. 15 Apr 1686
8
Elizabeth Comstock
[1.1.2.1.1.3.1.5]
b. Abt 1704
+
McCrary
b. 1702
8
Phoebe Comstock
[1.1.2.1.1.3.1.6]
b. 1706 d. 1 Dec 1790
Lemuel Griffin
b. 23 Mar 1706 d. 15 Aug 1788
9
George Griffin
[1.1.2.1.1.3.1.6.1]
b. 10 Jul 1734 d. 6 Aug 1814
9
Lemuel Griffin
[1.1.2.1.1.3.1.6.2]
b. Abt 1736 d. 9 Jul 1810
9
Josiah Griffen
[1.1.2.1.1.3.1.6.3]
b. 21 Jul 1743
8
Naomi Comstock
[1.1.2.1.1.3.1.7]
b. 1708 d. 29 May 1743
Consider Tiffany
b. 28 Apr 1703 d. 29 May 1763
9
Consider Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.1]
b. 15 Mar 1732 d. 19 Jun 1796
Sarah Wilder
b. 13 Aug 1738 d. 7 Nov 1818
10
Jemima Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.1.1]
b. 12 Oct 1756 d. 24 Jul 1784
10
Ephriam Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.1.2]
b. 8 Nov 1758 d. 7 Apr 1818
10
Dorothy Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.1.3]
b. 19 Jun 1762 d. 7 Nov 1818
10
Levi Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.1.4]
b. 23 Apr 1766 d. 20 Nov 1851
10
Consider Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.1.5]
b. 12 Mar 1769 d. 4 Sep 1859
10
Betty Wilder Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.1.6]
b. 25 Feb 1772 d. 16 Feb 1837
10
Mary Willey Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.1.7]
b. 1 Apr 1775
10
Lewis Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.1.8]
b. Abt 1777 d. 13 Nov 1777
10
Dolly Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.1.9]
b. Abt 1779
9
Luther Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.2]
b. 15 Apr 1734
9
Naomi Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.3]
b. 28 Dec 1737 d. 25 Jul 1821
Ezekial Huntley
b. 9 Mar 1728 d. 25 Jul 1783
10
Rufus Huntley
[1.1.2.1.1.3.1.7.3.1]
b. 18 Sep 1764 d. 4 Apr 1860
10
Lois Huntley
[1.1.2.1.1.3.1.7.3.2]
b. 18 Sep 1764 d. 2 Feb 1848
10
Elias Huntley
[1.1.2.1.1.3.1.7.3.3]
b. 28 Jul 1765 d. 10 Jan 1783
10
Asher Hulbert
[1.1.2.1.1.3.1.7.3.4]
b. 1 Mar 1767 d. 1 Mar 1849
10
Naomi Huntley
[1.1.2.1.1.3.1.7.3.5]
b. Abt 1768 d. 2 Dec 1840
10
Ezra Huntley
[1.1.2.1.1.3.1.7.3.6]
b. 2 Jun 1771 d. 13 Apr 1817
10
Ezekiel Huntley, Jr
[1.1.2.1.1.3.1.7.3.7]
b. 21 May 1780 d. 5 Mar 1853
9
Samuel Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4]
b. 13 Jul 1740 d. Mar 1822
Abigail Curtis
b. 17 Mar 1742 d. May 1820
10
Samuel Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.1]
b. 21 Oct 1761 d. 21 Apr 1851
Mary Sackett
b. Abt 1761 d. 1862
11
Samuel Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.1.1]
b. 1788 d. Abt 1845
11
Mary Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.1.2]
b. 1797
11
Julia Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.1.3]
b. 1799 d. 13 Jan 1891
11
Thomas Jefferson Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.1.4]
b. 1801
11
Hannah Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.1.5]
b. 5 Apr 1804 d. 10 Sep 1860
11
Calinda Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.1.6]
b. 2 Dec 1807 d. 5 Mar 1866
11
Ezekiel Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.1.7]
b. 1810
11
Jefferson Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.1.8]
b. Abt 1810
11
Harry Edward Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.1.9]
b. 25 Jun 1813 d. 14 Dec 1871
11
Harriet Emeline Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.1.10]
b. Abt 1815
11
Lorenzo Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.1.11]
b. Abt 1818
10
Nathanial Curtis Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.2]
b. 18 Feb 1762 d. 13 Feb 1857
Dency Crane
b. Abt 1765
11
Nathaniel Curtis Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.2.1]
b. Mar 1790
11
Harriet Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.2.2]
b. Mar 1792 d. 1858
11
Dancy Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.2.3]
b. 25 Sep 1795 d. 24 Mar 1846
11
Anron Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.2.4]
b. 2 Jun 1797 d. 27 Feb 1847
11
Betsey Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.2.5]
b. Abt 1799
11
David Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.2.6]
b. 1800
11
Mary Polly Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.2.7]
b. 17 Dec 1801 d. 20 May 1835
11
Elizabeth Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.2.8]
b. 1805
11
Caroline Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.2.9]
b. Abt 1807 d. 1843
10
Jemima Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.3]
b. 1763 d. 6 Mar 1848
Reuben Ward
b. 13 Nov 1748 d. 5 Jul 1825
11
Affa Ward
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.3.1]
b. 27 May 1783 d. 28 Feb 1877
William Stilson
b. 23 Sep 1783 d. 4 May 1862
12
Caroline Stilson
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.3.1.1]
b. 20 Jan 1808 d. 12 Jan 1883
12
Albert Stilson
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.3.1.2]
b. 16 Jan 1810 d. 30 Sep 1895
12
Celinda Stilson
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.3.1.3]
b. 4 Feb 1811 d. 26 Jun 1845
12
Emeline Stilson
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.3.1.4]
b. 27 Sep 1813 d. 6 Jan 1887
12
William M Stilson
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.3.1.5]
b. 2 Apr 1816
12
Saphronia Stilson
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.3.1.6]
b. 3 Nov 1817 d. 6 Jan 1887
12
Minor Stilson
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.3.1.7]
b. 9 Jan 1821
12
Affa C Stilson
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.3.1.8]
b. 31 Mar 1823 d. Abt 1879
12
Rueben R Stilson
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.3.1.9]
b. 29 Dec 1824
12
Allen Stilson
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.3.1.10]
b. 12 Apr 1827 d. 25 Jan 1878
11
Reuben Ward
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.3.2]
b. Abt 1784 d. 5 Mar 1876
11
Jemima Ward
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.3.3]
b. Abt 1786
11
Laura Ward
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.3.4]
b. Abt 1790
11
Eda Ward
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.3.5]
b. Abt 1788
11
Samuel Ward
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.3.6]
b. Abt 1792 d. 23 Feb 1873
11
Dorcas Ward
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.3.7]
b. Abt 1794
11
Cynthia Ward
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.3.8]
b. Abt 1796
+
Henry Rolluff
b. Abt 1782
11
William B Ward
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.3.9]
b. 1801
11
Daniel Ward
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.3.10]
b. 1807
10
William Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.4]
b. Abt 1765
10
Emellason Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.5]
b. Abt 1765 d. 18 Mar 1847
Sarah Aldrich
b. 4 Apr 1773
11
Rhoda Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.5.1]
b. 1 Nov 1793
11
George Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.5.2]
b. 5 May 1794
11
Lemuel Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.5.3]
b. 30 Jun 1796
11
David Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.5.4]
b. 18 Aug 1798
11
Sarah Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.5.5]
b. 27 Mar 1803 d. 14 Nov 1838
11
Silas Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.5.6]
b. 13 Apr 1809
10
Daniel Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.6]
b. 18 Sep 1768 d. 25 Sep 1793
+
Phebe Rand
b. Abt 1770
10
Abigail Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.7]
b. Abt 1770
+
Zenos Aldrich
b. 1766 d. 8 Nov 1856
10
George Obediah Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.8]
b. 7 May 1772 d. 13 Feb 1857
Mary Mason
b. Abt 1766 d. 16 Mar 1840
11
Abigail Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.8.1]
b. Abt 1797 d. Dec 1859
11
Zilpha Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.8.2]
b. Abt 1799 d. 1830
11
Zenas Schovil Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.8.3]
b. 25 Jun 1801 d. 1822
11
Luther Little Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.8.4]
b. 28 Mar 1803 d. 17 Feb 1881
11
Frederick Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.8.5]
b. 1804 d. 1804
11
Lorenzo Mason Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.8.6]
b. Abt 1804 d. Abt 1809
11
Jane Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.8.7]
b. 14 Apr 1805 d. 26 Nov 1867
11
George Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.8.8]
b. 4 May 1808 d. 21 Jun 1885
Almira Whipple
b. 13 Jun 1810 d. 4 Feb 1889
12
Cynthia Jane Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.8.8.1]
b. 2 Feb 1830 d. 6 Oct 1845
12
Zenos Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.8.8.2]
b. 21 Jul 1831 d. Dec 1843
12
Ira Patchen Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.8.8.3]
b. 14 Feb 1835 d. 21 Mar 1905 [
=>
]
12
Loyal Peck Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.8.8.4]
b. 27 Jul 1837 d. 15 Feb 1903
12
Mary Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.8.8.5]
b. 18 Dec 1844 d. 14 Dec 1845
12
Almira Rebecca Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.8.8.6]
b. 18 Aug 1847 d. 23 Nov 1914 [
=>
]
12
George Mason Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.8.8.7]
b. 31 Jan 1850 d. 14 Mar 1909 [
=>
]
12
Nelson Whipple Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.8.8.8]
b. 6 Aug 1852 d. 20 Jan 1927 [
=>
]
11
Lorenzo Roderick Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.8.9]
b. 4 Jul 1810 d. Abt 1810
11
Richard Mason Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.8.10]
b. 4 Jul 1810 d. 1897
11
Daniel Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.8.11]
b. 12 Sep 1812 d. 25 Jan 1894
11
Mary Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.8.12]
b. 28 Mar 1814 d. 1899
11
Phebe Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.8.13]
b. 24 Oct 1817 d. 20 Feb 1850
11
Larena Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.8.14]
b. 1818 d. 1844
11
Ann Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.8.15]
b. 4 Jun 1822 d. 12 Sep 1893
10
Mary Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9]
b. 17 Jun 1777 d. 12 Sep 1845
Daniel Whipple
b. 27 Aug 1779 d. 27 Sep 1839
11
Cynthia Whipple
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.1]
b. 15 Jan 1805 d. 1889
Ezra Gray
b. 1793 d. 1870
12
Hiram T Gray
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.1.1]
b. 25 Aug 1832 d. 30 Jun 1875
12
Daniel William Gray
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.1.2]
b. 19 May 1834 d. 9 Dec 1890 [
=>
]
12
Daughter Gray
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.1.3]
b. 1834
12
Emily Jane Gray
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.1.4]
b. 14 Nov 1837 d. 13 Feb 1908
12
Betsey T Gray
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.1.5]
b. 1840
12
Mary M Gray
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.1.6]
b. 1844
12
George W Gray
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.1.7]
b. 1846 d. 4 Aug 1918 [
=>
]
11
Samuel Whipple
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.2]
b. 21 Dec 1808 d. 9 Jan 1887
Phoebe Kingsbury
b. 14 Dec 1812 d. 24 Apr 1851
12
Sabrina Whipple
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.2.1]
b. 30 Mar 1832 d. 1920
12
George T Whipple
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.2.2]
b. 4 Dec 1833 d. 28 Aug 1868
12
Polly Whipple
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.2.3]
b. 4 Jun 1835 d. 24 Mar 1855
12
Daniel Whipple
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.2.4]
b. 21 Jun 1837
12
Margaret Whipple
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.2.5]
b. 18 Jun 1839 d. 8 Oct 1840
12
Mason Kingsbury Whipple
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.2.6]
b. 17 Feb 1842 d. 27 Mar 1919 [
=>
]
12
Samuel Whipple
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.2.7]
b. 4 Mar 1844 d. May 1924
12
Hassett Whipple
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.2.8]
b. 20 Feb 1846 d. 3 Jan 1852
12
Almira Whipple
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.2.9]
b. 21 Apr 1848 d. 22 Sep 1911
12
Cynthia Whipple
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.2.10]
b. 10 Nov 1850 d. 17 Apr 1851
11
Almira Whipple
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.3]
b. 13 Jun 1810 d. 4 Feb 1889
George Tiffany
b. 4 May 1808 d. 21 Jun 1885
12
Cynthia Jane Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.3.1]
b. 2 Feb 1830 d. 6 Oct 1845
12
Zenos Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.3.2]
b. 21 Jul 1831 d. Dec 1843
12
Ira Patchen Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.3.3]
b. 14 Feb 1835 d. 21 Mar 1905 [
=>
]
12
Loyal Peck Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.3.4]
b. 27 Jul 1837 d. 15 Feb 1903
12
Mary Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.3.5]
b. 18 Dec 1844 d. 14 Dec 1845
12
Almira Rebecca Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.3.6]
b. 18 Aug 1847 d. 23 Nov 1914 [
=>
]
12
George Mason Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.3.7]
b. 31 Jan 1850 d. 14 Mar 1909 [
=>
]
12
Nelson Whipple Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.3.8]
b. 6 Aug 1852 d. 20 Jan 1927 [
=>
]
11
Phoebe Whipple
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.4]
b. 13 Aug 1813 d. 18 Nov 1846
Benjamin Bengraw Shaw
b. 1808
12
Clymenia Azuba Shaw
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.4.1]
b. 2 Feb 1834 d. 10 Aug 1920 [
=>
]
Benjamin Gibson
b. 9 May 1805 d. 26 Nov 1897
12
Hannah Gibson
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.4.2]
b. 24 Apr 1836 d. 31 Oct 1846
12
Isabella Amy Gibson
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.4.3]
b. 20 Mar 1838 d. 11 Feb 1898 [
=>
]
12
Mary Jane Gibson
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.4.4]
b. 5 Feb 1840 d. 12 Jun 1912 [
=>
]
12
Susan Jane Gibson
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.4.5]
b. 11 Oct 1842 d. 25 May 1929 [
=>
]
12
Jemima Gibson
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.4.6]
b. 1847
11
Carum Whipple
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.5]
b. 12 Aug 1815 d. 1843
11
Gerua Whipple
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.6]
b. 12 Aug 1815 d. 18 Sep 1848
11
Nelson Wheeler Whipple
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.7]
b. 11 Jul 1818 d. 5 Jul 1887
Susan Jane Bailey
b. 9 Mar 1828 d. 5 Jun 1856
12
Son Whipple
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.7.1]
b. 15 Oct 1844 d. 15 Oct 1844
12
Miranda Jane Whipple
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.7.2]
b. 14 Mar 1847 d. 29 Dec 1907 [
=>
]
12
Mary Janet Whipple
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.7.3]
b. 14 Feb 1849 d. Nov 1922 [
=>
]
12
George Nelson Whipple
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.7.4]
b. 20 Mar 1851 d. 8 Jun 1912 [
=>
]
12
Edson Whipple
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.7.5]
b. 10 Oct 1853 d. 26 Feb 1909 [
=>
]
12
Harriet Emily Whipple
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.7.6]
b. 21 Nov 1855 d. 4 Oct 1856
12
Annie Bard Whipple
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.7.7]
b. 5 Jun 1856
Susan Ann Gay
b. 13 Jun 1841 d. 29 Sep 1911
12
Martha Ellen Whipple
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.7.8]
b. 19 Jan 1858 d. 20 Oct 1937 [
=>
]
12
Nelson Gay Whipple
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.7.9]
b. 21 Sep 1859 d. 2 Apr 1944 [
=>
]
12
Sylvia Gay Whipple
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.7.10]
b. 18 May 1862 d. 20 Jan 1940 [
=>
]
12
Susan Ann Whipple
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.7.11]
b. 3 Nov 1864 d. 19 Dec 1935 [
=>
]
12
Alexander Samuel Whipple
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.7.12]
b. 2 Mar 1867 d. 8 Jan 1899 [
=>
]
12
Robert John Whipple
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.7.13]
b. 13 Nov 1869 d. 6 Nov 1954 [
=>
]
12
Amey Jane Whipple
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.7.14]
b. 15 Dec 1871 d. 6 Sep 1962 [
=>
]
12
Ida Whipple
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.7.15]
b. 15 Dec 1873 d. 21 May 1956 [
=>
]
12
Anor Whipple
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.7.16]
b. 25 Mar 1879 d. 23 Oct 1967 [
=>
]
Rachel Keeling
b. 10 Mar 1818 d. 16 Jun 1910
12
Daniel Whipple
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.7.17]
b. 12 Apr 1854 d. 12 Feb 1926 [
=>
]
12
Cynthia Delight Whipple
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.7.18]
b. 7 Jun 1857 d. 4 Sep 1858
12
Nelson Wheeler Whipple, Jr
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.7.19]
b. 15 Apr 1859 d. 30 Jun 1938 [
=>
]
Zenos Aldrich
b. Abt 1773 d. 8 Nov 1856
11
Sylvanus Aldrich
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.8]
b. 1799 d. 8 Nov 1856
11
Azuba Aldrich
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.9]
b. Abt 1801
Armstrong Baskins
b. 3 Apr 1786 d. 27 May 1842
12
Sarah Ann Baskins
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.9.1]
b. Abt 1824
12
Harriet N Baskins
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.9.2]
b. Abt 1830
12
Mary Jane Baskins
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.9.3]
b. 1832 d. 22 Dec 1850
12
Erastus Baskins
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.9.9.4]
b. 1834 d. 3 Nov 1862
10
Azuba Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.10]
b. 22 Aug 1779 d. 13 Nov 1865
Jared Patchen
b. 5 Sep 1773 d. 1 May 1857
11
Martin Ray Patchen
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.10.1]
b. 10 Feb 1799 d. 7 Feb 1842
11
Abigail Patchen
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.10.2]
b. 23 Jan 1801 d. 7 Sep 1823
11
Emily Patchen
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.10.3]
b. 1802 d. 16 Jul 1826
11
John Patchen
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.10.4]
b. 14 Jan 1803 d. 23 Oct 1874
11
Ira Patchen
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.10.5]
b. 10 Jun 1805
11
Polly Patchen
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.10.6]
b. 20 Jan 1808 d. 21 Aug 1891
11
Mary Patchen
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.10.7]
b. 20 Jan 1808 d. 23 Feb 1888
11
Jared Patchen
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.10.8]
b. 6 Sep 1812
11
Sylvanus Aldridge Patchen
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.10.9]
b. 27 Nov 1814 d. 10 Feb 1892
11
Azuba Ann Patchen
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.10.10]
b. 4 Jun 1817 d. 29 Sep 1886
11
Hannah Lavinia Patchen
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.10.11]
b. 24 Apr 1820
11
Samuel Lorenzo Patchen
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.10.12]
b. 1 Aug 1823 d. 14 Jun 1867
11
Amy Patchen
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.10.13]
b. Abt 5 Jul 1825
10
Phoebe Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.11]
b. 22 Aug 1781 d. 31 Dec 1855
Nathan S Stewart
b. 7 Mar 1771 d. 7 Aug 1866
11
Horace S Stewart
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.11.1]
b. 15 Jun 1804 d. 7 Aug 1866
11
Erastus A Stewart
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.11.2]
b. 10 Mar 1805 d. 10 Nov 1851
11
Elijah Burr Stewart
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.11.3]
b. Abt 1809 d. 9 Nov 1880
11
Azuba Ann Stewart
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.11.4]
b. 1810
11
Samuel Curtis Stewart
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.11.5]
b. 1811 d. 25 Nov 1870
11
William Stewart
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.11.6]
b. 1812
11
Azubam Stewart
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.11.7]
b. 1812
11
Thomas Ryler Stewart
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.11.8]
b. 1815
10
Amy Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.12]
b. 8 Dec 1783 d. 17 Dec 1857
Isaac Darrow
b. Abt 1779
11
John Tiffany Darrow
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.12.1]
b. 17 Nov 1800 d. 13 Nov 1897
11
Affa Ward Darrow
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.12.2]
b. 26 Dec 1803 d. 15 Apr 1875
11
Hannah Mead Darrow
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.12.3]
b. 24 Apr 1806
11
Mary Cromwell Darrow
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.12.4]
b. 9 May 1808 d. 18 Nov 1877
11
Ann Hubbard Darrow
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.12.5]
b. 27 Mar 1811 d. 24 Jul 1890
11
Susan Pardee Darrow
[1.1.2.1.1.3.1.7.4.12.6]
b. 1813 d. 24 Jun 1890
9
Humphery Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.5]
b. 2 Mar 1742 d. 1831
Phebe Brown
b. Abt 1751 d. 1831
10
Lydia "Lidda" Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.5.1]
b. 13 May 1772 d. 1 Jul 1856
10
Susanna Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.5.2]
b. 28 Feb 1774
10
John C Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.5.3]
b. 17 Dec 1776 d. 9 Jul 1855
10
William Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.5.4]
b. Abt 1781 d. 12 Oct 1866
10
Phebe Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.5.5]
b. 1783
10
Humphrey Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.5.6]
b. 13 Sep 1788 d. 24 Jun 1870
10
Nelson Tiffany
[1.1.2.1.1.3.1.7.5.7]
b. 13 Sep 1808 d. 7 Sep 1869
8
Mary Comstock
[1.1.2.1.1.3.1.8]
b. Abt 1710
Nathan Beckwith
b. 22 Feb 1717 d. 24 Dec 1747
9
Mary Beckwith
[1.1.2.1.1.3.1.8.1]
b. Abt 1740 d. 10 Sep 1834
9
Ransom Beckwith
[1.1.2.1.1.3.1.8.2]
b. 12 Aug 1747
8
Samuel Comstock
[1.1.2.1.1.3.1.9]
b. Abt 1712 d. 1787
7
Moses Noyes
[1.1.2.1.1.3.2]
b. 1 Aug 1678 d. 10 Oct 1743
Mary Ely
b. 29 Nov 1689 d. 3 Feb 1764
8
Ruth Noyes
[1.1.2.1.1.3.2.1]
b. 1722 d. 14 May 1725
8
Moses Noyes
[1.1.2.1.1.3.2.2]
b. 1 Sep 1714 d. 23 Jul 1753
8
Ruth Noyes
[1.1.2.1.1.3.2.3]
b. 6 Jan 1716 d. 5 Feb 1719
8
Elizabeth Noyes
[1.1.2.1.1.3.2.4]
b. 1730 d. 8 May 1819
Jabez Sill
b. 4 Aug 1722 d. 14 Mar 1795
9
Elizabeth Noyes Sill
[1.1.2.1.1.3.2.4.1]
b. 22 Oct 1750 d. 27 Apr 1812
9
Mary Sill
[1.1.2.1.1.3.2.4.2]
b. 11 Jul 1752 d. 22 Apr 1842
9
Naomi Sill
[1.1.2.1.1.3.2.4.3]
b. 28 Nov 1754 d. 1838
9
Esther Sill
[1.1.2.1.1.3.2.4.4]
b. 1755 d. 7 Aug 1817
9
Shadrach Sill
[1.1.2.1.1.3.2.4.5]
b. 12 Aug 1758 d. 3 Nov 1813
9
Moses Sill
[1.1.2.1.1.3.2.4.6]
b. Abt 1760 d. Aug 1850
9
Dr Elisha Noyes Sill
[1.1.2.1.1.3.2.4.7]
b. 1761 d. 24 May 1845
9
Jabez Sill, Jr
[1.1.2.1.1.3.2.4.8]
b. 6 Mar 1763 d. 29 Jul 1838
9
Amasa Sill
[1.1.2.1.1.3.2.4.9]
b. 8 Jan 1767 d. 1772
9
Sarah Sill
[1.1.2.1.1.3.2.4.10]
b. 11 Oct 1770 d. 1779
8
William Noyes
[1.1.2.1.1.3.2.5]
b. 1735 d. 11 Feb 1807
Eunice Marvin
b. 2 Dec 1735 d. 5 Apr 1816
9
John Noyes
[1.1.2.1.1.3.2.5.1]
b. 18 Dec 1756 d. 1808
9
Captain Joseph Noyes
[1.1.2.1.1.3.2.5.2]
b. 1758 d. 1820
9
William Noyes
[1.1.2.1.1.3.2.5.3]
b. 30 Oct 1760 d. 23 Dec 1834
9
Matthew Noyes
[1.1.2.1.1.3.2.5.4]
b. 26 Feb 1764 d. 25 Sep 1839
7
Ruth Noyes
[1.1.2.1.1.3.3]
b. 6 Jan 1680 d. 5 May 1774
James Wadsworth
b. 1677 d. 1756
8
James Wadsworth
[1.1.2.1.1.3.3.1]
b. Abt 1700 d. 1777
Abigail Penfield
b. 22 Dec 1704 d. 1748
9
James Wadsworth
[1.1.2.1.1.3.3.1.1]
b. 8 Jul 1730 d. 22 Sep 1817
9
John Noyes Wadsworth
[1.1.2.1.1.3.3.1.2]
b. 1732 d. 1786
9
Ruth Wadsworth
[1.1.2.1.1.3.3.1.3]
b. 1743 d. 20 Jun 1813
Caleb Atwater
b. 7 Sep 1741 d. 19 Dec 1831
10
Anne Atwater
[1.1.2.1.1.3.3.1.3.1]
b. 17 Nov 1765
10
Joshua Atwater
[1.1.2.1.1.3.3.1.3.2]
b. Abt 1766
10
James Wadsworth Atwater
[1.1.2.1.1.3.3.1.3.3]
b. 30 Jun 1777 d. 30 Oct 1777
10
Abigail Atwater
[1.1.2.1.1.3.3.1.3.4]
b. 3 Dec 1778 d. 3 Sep 1834
10
Catharine Atwater
[1.1.2.1.1.3.3.1.3.5]
b. Abt 1780
10
Catherine "Kate" Atwater
[1.1.2.1.1.3.3.1.3.6]
b. 25 May 1781
10
Ruth Atwater
[1.1.2.1.1.3.3.1.3.7]
b. 11 Apr 1788 d. 2 Nov 1877
7
Sarah Noyes
[1.1.2.1.1.3.4]
b. 1682 d. 16 Aug 1756
Captain Timothy Mather
b. 20 Mar 1681 d. 25 Jul 1755
8
Timothy Mather
[1.1.2.1.1.3.4.1]
b. 9 Oct 1711
8
Joseph Mather
[1.1.2.1.1.3.4.2]
b. 23 Feb 1713 d. 5 Feb 1778
8
Ruth Mather
[1.1.2.1.1.3.4.3]
b. 3 Dec 1715 d. 4 Dec 1790
8
Catharine Mather
[1.1.2.1.1.3.4.4]
b. 1717 d. 4 Dec 1799
8
Moses Mather
[1.1.2.1.1.3.4.5]
b. 1718 d. 21 Sep 1806
7
John Noyes
[1.1.2.1.1.3.5]
b. 21 Jan 1688 d. 14 Feb 1755
Jane Dole
b. 23 Jan 1692 d. 14 Feb 1755
8
Josiah Noyes
[1.1.2.1.1.3.5.1]
b. 8 Sep 1712 d. 18 Feb 1796
8
Dorothy Noyes
[1.1.2.1.1.3.5.2]
b. 9 Apr 1715 d. 19 Mar 1798
8
Hannah Noyes
[1.1.2.1.1.3.5.3]
b. 6 Jul 1720 d. Bef Dec 1761
8
Jane Noyes
[1.1.2.1.1.3.5.4]
b. 8 Jan 1722
8
Oliver Noyes
[1.1.2.1.1.3.5.5]
b. 19 Mar 1724 d. 30 Apr 1725
8
Amos Noyes
[1.1.2.1.1.3.5.6]
b. 29 Jul 1728 d. 1752
8
Lieutenant colonel Peter Noyes
[1.1.2.1.1.3.5.7]
b. 3 Dec 1731 d. Aug 1796
6
John Noyes
[1.1.2.1.1.4]
b. 4 Jun 1649 d. 9 Nov 1678
Sarah Oliver
b. 7 Nov 1643 d. 19 Mar 1707
7
Sarah Noyes
[1.1.2.1.1.4.1]
b. 20 Aug 1672
7
John Noyes
[1.1.2.1.1.4.2]
b. 4 Nov 1674 d. 15 Mar 1749
Susanna Edwards
b. 29 Oct 1676
8
John Noyes
[1.1.2.1.1.4.2.1]
b. 17 Dec 1699 d. 1699
8
Sarah Noyes
[1.1.2.1.1.4.2.2]
b. 31 Mar 1701 d. 24 Aug 1702
8
Mary Noyes
[1.1.2.1.1.4.2.3]
b. 30 Oct 1703
8
Susanna Noyes
[1.1.2.1.1.4.2.4]
b. 15 Jun 1705
8
John Noyes
[1.1.2.1.1.4.2.5]
b. 26 Jun 1706 d. 26 Jun 1706
8
Sarah Noyes
[1.1.2.1.1.4.2.6]
b. 18 Sep 1712
8
Abigail Noyes
[1.1.2.1.1.4.2.7]
b. 21 May 1716 d. 12 Jun 1737
8
John Noyes
[1.1.2.1.1.4.2.8]
b. 8 Aug 1718
7
Dr Oliver Noyes
[1.1.2.1.1.4.3]
b. 1675 d. 16 Mar 1720
6
Thomas Noyes
[1.1.2.1.1.5]
b. 10 Aug 1648 d. 24 Apr 1730
Elizabeth Greenleaf
b. 5 Apr 1660 d. 30 Apr 1702
7
Moses Noyes
[1.1.2.1.1.5.1]
b. 29 Jan 1692 d. 1775
7
Mary Noyes
[1.1.2.1.1.5.2]
b. 8 Sep 1686 d. 1758
7
Parker Noyes
[1.1.2.1.1.5.3]
b. 29 Oct 1661 d. Bef 1710
7
Judith Noyes
[1.1.2.1.1.5.4]
b. Abt 1692 d. 30 Sep 1790
7
Thomas Noyes
[1.1.2.1.1.5.5]
b. 2 Oct 1679 d. 10 Jul 1753
7
Joseph Noyes
[1.1.2.1.1.5.6]
b. Abt 1686 d. 3 May 1750
7
Stephen Noyes
[1.1.2.1.1.5.7]
b. 6 Jul 1686
7
Elizabeth Noyes
[1.1.2.1.1.5.8]
b. 19 Feb 1684
7
Rebecca Noyes
[1.1.2.1.1.5.9]
b. 19 Apr 1700
6
Rebecca Noyes
[1.1.2.1.1.6]
b. 1 Apr 1651 d. 15 Oct 1719
John Knight
b. 16 Aug 1648 d. 7 Feb 1695
7
Bathsheba Knight
[1.1.2.1.1.6.1]
b. 1671
7
James Knight
[1.1.2.1.1.6.2]
b. 3 Sep 1672 d. Mar 1736
7
Rebecca Knight
[1.1.2.1.1.6.3]
b. 27 Apr 1674 d. Aft 1700
7
Mary Knight
[1.1.2.1.1.6.4]
b. Abt 1674 d. Abt 1725
Stephen Thurston
b. 5 Feb 1674
8
Moses Thurston
[1.1.2.1.1.6.4.1]
b. 19 Jul 1707 d. 12 Oct 1756
8
John Thurston
[1.1.2.1.1.6.4.2]
b. 29 Aug 1709 d. 28 Apr 1773
8
Rebecca Thurston
[1.1.2.1.1.6.4.3]
b. 1711
8
Robert Thurston
[1.1.2.1.1.6.4.4]
b. 25 Feb 1713 d. 16 Feb 1752
8
Daniel Thurston
[1.1.2.1.1.6.4.5]
b. 27 Aug 1714 d. 16 Feb 1737
8
Mary Thurston
[1.1.2.1.1.6.4.6]
b. 2 Jun 1716 d. 12 Oct 1775
8
Nathanial Thurston
[1.1.2.1.1.6.4.7]
b. 12 Jul 1718 d. 12 Oct 1775
8
Stephen Thurston
[1.1.2.1.1.6.4.8]
b. Abt 1720 d. 27 Nov 1732
8
Mehitable Thurston
[1.1.2.1.1.6.4.9]
b. 1721
7
Sarah Knight
[1.1.2.1.1.6.5]
b. 10 Dec 1675 d. 16 Aug 1690
7
John Knight
[1.1.2.1.1.6.6]
b. 3 Apr 1676 d. Aft 1725
7
Nathaniel Knight
[1.1.2.1.1.6.7]
b. 22 Dec 1688 d. 29 Oct 1754
7
Joseph Knight
[1.1.2.1.1.6.8]
b. 9 Oct 1683 d. 31 Jan 1746
7
Elizabeth Knight
[1.1.2.1.1.6.9]
b. 5 Jul 1696 d. 5 Jul 1774
6
William Noyes
[1.1.2.1.1.7]
b. 22 Sep 1653 d. 10 Mar 1744
Sarah Cogswell
b. 3 Feb 1668 d. Bef 1716
7
Moses Noyes
[1.1.2.1.1.7.1]
b. 27 Jan 1693 d. 16 Feb 1693
7
Mary Noyes
[1.1.2.1.1.7.2]
b. 24 May 1699 d. 16 Dec 1703
7
Sarah Noyes
[1.1.2.1.1.7.3]
b. 10 May 1691 d. 3 Dec 1703
7
John Noyes
[1.1.2.1.1.7.4]
b. 27 Jul 1686 d. 4 Jan 1772
7
Seusanah Noyes
[1.1.2.1.1.7.5]
b. Abt 1687 d. 6 Apr 1754
7
Parker Noyes
[1.1.2.1.1.7.6]
b. 17 Jan 1704 d. 22 Sep 1784
6
Sarah Noyes
[1.1.2.1.1.8]
b. 21 Mar 1655 d. 20 May 1697
John Hale
b. 24 Mar 1675 d. 4 Apr 1761
7
James Hale
[1.1.2.1.1.8.1]
b. 14 Oct 1685 d. 22 Nov 1742
Sarah Hathaway
b. Abt 1686
8
John Hale
[1.1.2.1.1.8.1.1]
b. 19 Apr 1715 d. 7 Jun 1738
8
James Hale, Jr
[1.1.2.1.1.8.1.2]
b. 9 Feb 1716 d. Bef 1774
7
John Hale
[1.1.2.1.1.8.2]
b. 24 Jun 1686 d. 29 Nov 1739
7
Samuel Hale
[1.1.2.1.1.8.3]
b. 13 Aug 1687 d. 29 May 1724
7
Joanna Hale
[1.1.2.1.1.8.4]
b. 15 Jun 1689 d. 1713
7
Robert Hale
[1.1.2.1.1.8.5]
b. 3 Nov 1688 d. 1719
7
John Hale
[1.1.2.1.1.8.6]
b. 24 Dec 1692
3
Ann Browne
[1.1.3]
b. 1603 d. 4 Dec 1669
Thomas Hutchinson
b. 1605 d. Abt 1630
4
Samuel Hutchinson
[1.1.3.1]
b. 1620 d. 23 Aug 1641
4
Elizabeth Hutchinson
[1.1.3.2]
b. 1622 d. 28 Nov 1700
Isaac Hart
b. 1614 d. 10 Feb 1699
5
Elizabeth Hart
[1.1.3.2.1]
b. 11 Dec 1651 d. 1745
5
Deborah Hart
[1.1.3.2.2]
b. 1653 d. 16 Jun 1710
Joseph Morgan
b. 1641 d. 23 Oct 1732
6
Reverend Joseph Morgan
[1.1.3.2.2.1]
b. 6 Nov 1671 d. 1742
6
Deborah Morgan
[1.1.3.2.2.2]
b. 1679
Jabez Baker
b. 29 Mar 1665 d. 24 Aug 1758
7
Debora Baker
[1.1.3.2.2.2.1]
b. 1700 d. 2 May 1726
7
Elizabeth Baker
[1.1.3.2.2.2.2]
b. 24 Nov 1702
7
John Baker
[1.1.3.2.2.2.3]
b. 15 Apr 1706
7
Joseph Baker
[1.1.3.2.2.2.4]
b. 24 Mar 1708
7
Abigail Baker
[1.1.3.2.2.2.5]
b. 5 Oct 1714 d. 17 Jun 1758
Daniel Massey
b. 5 Aug 1714 d. 21 Mar 1787
8
Deborah Massey
[1.1.3.2.2.2.5.1]
b. 1720 d. Abt 1801
James Huntsman
b. 14 Apr 1717 d. 10 Oct 1749
9
John Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.1]
b. 1738
9
James Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2]
b. 19 Apr 1740 d. 1844
Deborah Palmer
b. 3 Jan 1749 d. Bef 1830
10
John Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.1]
b. 1768 d. 1857
Mary Elizabeth Snyder
b. 1765 d. Abt 1832
11
Jonathan Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.1.1]
b. 1788
11
James Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.1.2]
b. 1789
11
Elizabeth Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.1.3]
b. 1790
11
Son Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.1.4]
b. 1792
11
Joseph Snider Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.1.5]
b. Abt 1794 d. 30 Mar 1836
11
Margaret Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.1.6]
b. Abt 1797
11
William Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.1.7]
b. 3 Nov 1798 d. 8 Jan 1883
11
Son Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.1.8]
b. 1800
10
James Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2]
b. 16 Jun 1770 d. 13 Dec 1823
Maria Cathrina Weyrich
b. 15 Aug 1775 d. 21 Nov 1824
11
Jonathan Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.1]
b. 8 Mar 1792 d. 30 Jan 1860
Nancy Wherry
b. 30 Nov 1794 d. 19 Feb 1859
12
William C Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.1.1]
b. 25 Jan 1817 d. 10 May 1901 [
=>
]
12
Israel Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.1.2]
b. 24 Aug 1819 d. Abt 1902
12
Josiah Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.1.3]
b. 6 Apr 1821 d. Abt 1881
12
James Wherry Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.1.4]
b. 5 May 1824 d. 23 Jan 1912
12
John William Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.1.5]
b. 1 Apr 1826 d. Bef 1855
12
Noah Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.1.6]
b. 28 Mar 1828 d. 1879
12
Amariah C Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.1.7]
b. 25 Jun 1830 d. 8 Oct 1902
12
Mary Jane Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.1.8]
b. 24 Dec 1833 d. 23 Jan 1862
12
Sarah Ann Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.1.9]
b. 30 Dec 1837 d. 25 Jan 1860
11
Sophrona Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.2]
b. Abt 1793 d. 1869
11
Peter Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.3]
b. 1798 d. Feb 1853
Catherine Steltz
b. 14 Oct 1800 d. 1 Sep 1885
12
William Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.3.1]
b. 23 May 1822 d. 25 Aug 1902
12
James Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.3.2]
b. 1826 d. 1889
12
Alfred Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.3.3]
b. 15 May 1829 d. 26 May 1896
12
Mary Ann Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.3.4]
b. 24 Nov 1830 d. 31 Mar 1907 [
=>
]
12
Cyrus Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.3.5]
b. 1831
12
Levi Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.3.6]
b. 6 Sep 1835 d. 29 Mar 1869 [
=>
]
12
Margaret Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.3.7]
b. 20 Oct 1839 d. 27 Dec 1907
11
James Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.4]
b. 6 Jun 1801 d. 10 Nov 1871
Mary Johnston
b. 6 May 1801 d. 15 Aug 1895
12
Lavinia Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.4.1]
b. 1 Apr 1823 d. 17 Sep 1868 [
=>
]
12
Catharine J Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.4.2]
b. 27 Sep 1824 d. 24 Dec 1903 [
=>
]
12
Isaiah Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.4.3]
b. 14 Sep 1826 d. 3 Jun 1878 [
=>
]
12
Isaac Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.4.4]
b. 19 Aug 1828 d. 15 Jul 1850
12
Gabriel Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.4.5]
b. 5 Oct 1830 d. 5 Aug 1907 [
=>
]
12
William Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.4.6]
b. 28 Jul 1832 d. 11 Feb 1911 [
=>
]
12
Jacob Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.4.7]
b. 5 Jul 1834 d. 26 Jun 1914 [
=>
]
12
Jesse Allan Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.4.8]
b. 19 Sep 1836 d. 17 Oct 1914 [
=>
]
12
Peter Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.4.9]
b. 28 Feb 1839 d. 4 Feb 1929 [
=>
]
12
Keziah Turner Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.4.10]
b. 21 Sep 1843 d. 14 Apr 1866 [
=>
]
12
Sarah Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.4.11]
b. 3 Jun 1841 d. 5 Apr 1881 [
=>
]
+
Elizabeth Greenaugh
b. Abt 1804
+
Hannah Coleman
b. Abt 1804
11
William Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.5]
b. 11 Apr 1803 d. 2 Dec 1887
Ingrid Beta Johanson
b. 13 Sep 1833 d. 21 Jun 1919
12
Hannah Johanna Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.5.1]
b. 1874 d. 1874
12
William Huntsman, Jr
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.5.2]
b. 21 Apr 1875 d. 18 Oct 1889
12
Sarah Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.5.3]
b. 5 Apr 1880 d. 13 Jan 1949
11
Monida Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.6]
b. 1808 d. 1810
11
Jacob Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.7]
b. 18 Feb 1807 d. 1 Mar 1898
Catharine Weirick
b. 22 Feb 1817 d. 27 Feb 1898
12
Decatur Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.7.1]
b. 8 Mar 1837 d. 1838
12
Deborah Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.7.2]
b. 1 Feb 1839 d. Abt 1899
12
Amelia Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.7.3]
b. 26 Jan 1843 d. Abt 1903
12
De Porter Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.7.4]
b. 31 Dec 1845 d. 18 Mar 1916
12
Jacob Taylor Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.7.5]
b. 1847 d. Abt 1918
12
George Ammon Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.7.6]
b. 25 Jan 1850 d. 17 Mar 1939
12
Lavina Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.7.7]
b. 1852
12
Ervina Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.7.8]
b. 28 Feb 1853 d. Abt 1913
12
Javis Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.7.9]
b. 1 Mar 1856 d. 6 Aug 1930
12
Ethan Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.7.10]
b. Dec 1859 d. 1870
12
Ether Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.7.11]
b. 24 Dec 1859
11
Jeremiah Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.8]
b. 1 Mar 1809 d. 12 Mar 1879
Mary Painter
b. 24 Sep 1814 d. 21 Oct 1899
12
Lydia Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.8.1]
b. Abt 1833 d. 1912
12
John Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.8.2]
b. 1837
12
George Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.8.3]
b. 27 Oct 1840 d. 16 Feb 1911
12
Rachel Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.8.4]
b. 7 Feb 1842 d. 7 Feb 1905
12
Mary J. Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.8.5]
b. 1845 d. 1900
12
Arminda Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.8.6]
b. 30 Mar 1847 d. 25 Nov 1922
12
Riley Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.8.7]
b. 14 Feb 1849 d. 10 Feb 1933
12
Samantha Loretta Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.8.8]
b. Dec 1852 d. 1923
12
Almeda Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.8.9]
b. 1856
12
Martha Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.8.10]
b. Abt 1860
12
Milford Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.8.11]
b. 1865
12
Elmer Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.8.12]
b. 1867
11
Samuel Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.2.9]
b. 1809 d. 1850
10
Jesse Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.3]
b. Abt 1772 d. 26 Sep 1836
Catherine Call
b. 1773 d. 1812
11
Nancy Ann Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.3.1]
b. 1795 d. 1843
11
Sarah Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.3.2]
b. 2 Nov 1797 d. 5 Feb 1873
11
Elizabeth Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.3.3]
b. 25 Sep 1800 d. 4 Jan 1875
11
Lucy Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.3.4]
b. 19 Oct 1802
11
Jesse Huntsman, Jr
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.3.5]
b. 21 Oct 1804 d. 24 Dec 1860
11
James William Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.3.6]
b. 8 Oct 1806 d. 26 Feb 1867
11
Lydia Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.3.7]
b. 19 Oct 1816 d. 1817
11
Margaret Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.3.8]
b. 1818
11
Deborah Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.3.9]
b. 1820
11
Peter Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.3.10]
b. 1822 d. 1823
10
Martha Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.4]
b. Abt 1774
10
William Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.5]
b. 1776 d. 1857
Mary Oberholtzer
b. 1776
11
Louis Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.5.1]
b. 25 Jun 1794 d. 28 Apr 1795
11
John Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.5.2]
b. Abt 1796
10
Mary Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.6]
b. 1782
+
John Greenaugh
b. 1780
10
Andrew Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.7]
b. Abt 1784 d. 1822
Susanna
b. 1785
11
Judia Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.7.1]
b. 8 Dec 1816
11
Joseph Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.2.7.2]
b. 24 May 1822
9
Richard John Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.3]
b. 1744
9
Jonathan Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.4]
b. 1745
9
Mary Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.5]
b. 1746
9
Elizabeth Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.6]
b. 1747
9
Sarah Huntsman
[1.1.3.2.2.2.5.1.7]
b. 1748 d. 23 Aug 1797
8
Sarah Massey
[1.1.3.2.2.2.5.2]
b. 16 Oct 1734 d. 15 Mar 1803
8
Daniel Massey, Jr
[1.1.3.2.2.2.5.3]
b. 16 Oct 1734 d. 27 Oct 1754
8
Abigail Massay
[1.1.3.2.2.2.5.4]
b. 17 Aug 1736 d. 29 May 1797
8
Rebecca Massey
[1.1.3.2.2.2.5.5]
b. 2 Sep 1745
8
Jonathan Massey
[1.1.3.2.2.2.5.6]
b. 6 Jul 1747 d. 3 Mar 1830
8
Elizabeth Massey
[1.1.3.2.2.2.5.7]
c. 24 Jul 1743
7
Robert Baker
[1.1.3.2.2.2.6]
b. 24 Aug 1717
6
Benjamin Morgan
[1.1.3.2.2.3]
b. 12 Mar 1683 d. 1734
6
Merriam Morgan
[1.1.3.2.2.4]
b. 12 Jul 1685 d. 1764
6
Abigail Morgan
[1.1.3.2.2.5]
b. Sep 1687
6
Moses Morgan
[1.1.3.2.2.6]
b. 6 Sep 1688 d. 1732
6
Sarah Morgan
[1.1.3.2.2.7]
b. 14 Oct 1691
6
Jonathan Morgan
[1.1.3.2.2.8]
b. 1693 d. 1693
5
John Hart
[1.1.3.2.3]
b. 1655
5
Samuel Hart
[1.1.3.2.4]
b. 9 Feb 1656 d. 30 Dec 1730
Sarah Endecott
b. 19 Dec 1673
6
Thomas Hart
[1.1.3.2.4.1]
b. 12 Aug 1696
6
John Hart
[1.1.3.2.4.2]
b. 25 Mar 1703 d. 1777
6
Samuel Hart, Jr
[1.1.3.2.4.3]
b. 30 Oct 1698 d. 28 Dec 1758
Hephzibah Pearson
b. 3 Apr 1699 d. 1740
7
Ebenezer Hart
[1.1.3.2.4.3.1]
b. Abt 1738
Sarah Poole
b. 15 Apr 1740 d. Jan 1824
8
Prudence Hart
[1.1.3.2.4.3.1.1]
b. Abt 1759
8
Sarah Hart
[1.1.3.2.4.3.1.2]
b. 12 Jan 1761 d. 3 Sep 1820
8
Judith Hart
[1.1.3.2.4.3.1.3]
b. 1762 d. Nov 1828
8
Rebecca Hart
[1.1.3.2.4.3.1.4]
b. 1763 d. 1840
Oliver Bates
b. 7 Aug 1763 d. 8 Jun 1828
9
Oliver Bates
[1.1.3.2.4.3.1.4.1]
b. 7 Jun 1784 d. 1855
9
Asa Bates
[1.1.3.2.4.3.1.4.2]
b. 3 Aug 1786 d. Aft 1855
9
Polly Bates
[1.1.3.2.4.3.1.4.3]
b. 16 Mar 1789 d. 19 May 1803
9
Cyrus Bates
[1.1.3.2.4.3.1.4.4]
b. 17 Feb 1792 d. 3 Oct 1839
Lydia Harrington
b. 7 Dec 1795 d. 28 Dec 1873
10
Nelson Bates
[1.1.3.2.4.3.1.4.4.1]
b. 23 Dec 1813 d. 16 Dec 1885
10
Ormus Ephraim Bates
[1.1.3.2.4.3.1.4.4.2]
b. 25 Mar 1815 d. 4 Aug 1873
10
Sarah Marinda Bates
[1.1.3.2.4.3.1.4.4.3]
b. 5 Feb 1817 d. 25 Dec 1888
10
Lovina Arminda Bates
[1.1.3.2.4.3.1.4.4.4]
b. 5 Jan 1819 d. 26 Feb 1884
10
Marcellus Bates
[1.1.3.2.4.3.1.4.4.5]
b. 28 Aug 1821 d. 4 Nov 1902
10
Orissa Angelia Bates
[1.1.3.2.4.3.1.4.4.6]
b. 17 Aug 1823 d. 29 Jan 1878
William Moore Allred
b. 24 Dec 1819 d. 8 Jun 1901
11
William Lansing Allred
[1.1.3.2.4.3.1.4.4.6.1]
b. 18 Oct 1842 d. 28 Jan 1915
11
Mary Adaline Allred
[1.1.3.2.4.3.1.4.4.6.2]
b. 20 Dec 1844 d. 24 Feb 1914
11
Byron Harvey Allred
[1.1.3.2.4.3.1.4.4.6.3]
b. 29 May 1847 d. 6 Aug 1912
Mary Eliza Tracy
b. 3 Mar 1874 d. 30 Sep 1949
12
Byron Harvey Allred, Jr
[1.1.3.2.4.3.1.4.4.6.3.1]
b. 31 Mar 1870 d. 18 Jan 1937
12
Myra Irene Allred
[1.1.3.2.4.3.1.4.4.6.3.2]
b. 10 Apr 1872 d. 9 Sep 1912
12
Henry Garcia Allred
[1.1.3.2.4.3.1.4.4.6.3.3]
b. 8 Feb 1895 d. 19 Nov 1954
12
Lorain Tracy Allred
[1.1.3.2.4.3.1.4.4.6.3.4]
b. 26 Feb 1897 d. 26 Nov 1897
12
Lorain Tracy Allred
[1.1.3.2.4.3.1.4.4.6.3.5]
b. 26 Feb 1897 d. 26 Oct 1897
12
Lavon Tracy Allred
[1.1.3.2.4.3.1.4.4.6.3.6]
b. 7 Oct 1901 d. 29 Aug 1995
12
Mary Viola Allred
[1.1.3.2.4.3.1.4.4.6.3.7]
b. 26 Apr 1904 d. 15 Jan 2000 [
=>
]
11
Marvin Adelbert Allred
[1.1.3.2.4.3.1.4.4.6.4]
b. 1849 d. 1 May 1916
11
Amelia Lorinda Allred
[1.1.3.2.4.3.1.4.4.6.5]
b. 30 Jul 1851 d. 30 Jul 1851
11
Melvin Hilbert Allred
[1.1.3.2.4.3.1.4.4.6.6]
b. 11 Oct 1853 d. 16 Dec 1854
11
Medwin Newton Allred
[1.1.3.2.4.3.1.4.4.6.7]
b. 20 Feb 1855 d. 29 Jul 1895
11
Orissa Angelia Allred
[1.1.3.2.4.3.1.4.4.6.8]
b. 16 Jun 1857 d. 14 May 1922
11
Lydia Lavette Allred
[1.1.3.2.4.3.1.4.4.6.9]
b. 23 Sep 1859 d. 24 Apr 1917
11
Martha Jane Allred
[1.1.3.2.4.3.1.4.4.6.10]
b. 9 Nov 1860 d. Nov 1860
11
Seymour LeGrand Allred
[1.1.3.2.4.3.1.4.4.6.11]
b. 15 Apr 1862 d. 27 Apr 1923
11
Nelson Calvert Allred
[1.1.3.2.4.3.1.4.4.6.12]
b. 5 Oct 1865 d. 2 Mar 1929
11
Elizabeth Allred
[1.1.3.2.4.3.1.4.4.6.13]
b. Abt 1866
11
Orson Pratt Allred
[1.1.3.2.4.3.1.4.4.6.14]
b. 29 Nov 1867 d. 19 Mar 1910
11
Delorus Allred
[1.1.3.2.4.3.1.4.4.6.15]
b. 20 Jul 1895 d. 22 Sep 1979
10
Lydia Augusta Bates
[1.1.3.2.4.3.1.4.4.7]
b. 29 Apr 1825 d. 23 May 1903
10
Cyrus Wakefield Bates
[1.1.3.2.4.3.1.4.4.8]
b. 22 Jan 1827 d. 19 Jan 1895
10
Julia Ann Bates
[1.1.3.2.4.3.1.4.4.9]
b. 7 Feb 1828 d. 5 Mar 1892
10
Lansing Bates
[1.1.3.2.4.3.1.4.4.10]
b. 19 Apr 1831 d. 18 Jun 1877
9
Elias Bates
[1.1.3.2.4.3.1.4.5]
b. 30 Aug 1794 d. 17 Jul 1883
9
Hart Bates
[1.1.3.2.4.3.1.4.6]
b. 17 Mar 1797 d. Aft 1850
9
Laura Bates
[1.1.3.2.4.3.1.4.7]
b. 8 Jul 1799 d. Aft 1870
9
Fanny Bates
[1.1.3.2.4.3.1.4.8]
b. 28 Sep 1801 d. 22 Jul 1857
8
Eunice Hart
[1.1.3.2.4.3.1.5]
b. Abt 1765
8
Hart
[1.1.3.2.4.3.1.6]
b. 18 Feb 1770
8
Ebenezer Hart
[1.1.3.2.4.3.1.7]
b. 22 Apr 1773 d. 24 Dec 1857
8
Rhoda Hart
[1.1.3.2.4.3.1.8]
b. 20 May 1775 d. 30 Oct 1849
5
Rebecca Hart
[1.1.3.2.5]
b. Abt 1660 d. 1 Jun 1670
5
Adam Hart
[1.1.3.2.6]
b. 4 Apr 1666 d. 17 Sep 1745
4
Thomas Hutchinson
[1.1.3.3]
b. 1624
4
Francis Hutchinson
[1.1.3.4]
b. 1630 d. Abt 1694
2
John Browne
[1.2]
b. Abt 1575 bur. 5 May 1616
Margaret Laurence
b. Abt 1575
3
Isabel Brown
[1.2.1]
b. Abt 1572 d. Oct 1639
George Erskine
b. 1579 d. 2 Jun 1646
4
George Erskine
[1.2.1.1]
b. Abt 1599
4
Anna Erskine
[1.2.1.2]
b. Abt 1602 d. Aft 1643
4
Margaret Erskine
[1.2.1.3]
b. Abt 1608 d. Jun 1693
James Greemhorne
c. 24 Mar 1606
5
Margaret Greemhorne
[1.2.1.3.1]
b. Abt 1635
John Peter
b. Abt 1631
6
Jonet Peter
[1.2.1.3.1.1]
b. 26 Apr 1657 d. 1759
Patrik Gairdner
b. Abt 1642 d. 1759
7
John Gardner
[1.2.1.3.1.1.1]
b. Abt 1692
7
Janet Gardner
[1.2.1.3.1.1.2]
b. 31 Jan 1692 d. Bef 1711
7
Margaret Gardner
[1.2.1.3.1.1.3]
b. 10 Aug 1697 d. Bef 1703
7
Elizabeth Gardner
[1.2.1.3.1.1.4]
b. 24 Feb 1702
7
Agnes Gardener
[1.2.1.3.1.1.5]
b. 26 Aug 1705
William Russell
b. Abt 1707
8
William Russell
[1.2.1.3.1.1.5.1]
b. 21 May 1731
Christina Thomson
b. Dec 1732 d. 1762
9
Cecelia Russell
[1.2.1.3.1.1.5.1.1]
b. 27 Sep 1753 d. 28 Oct 1823
John Sharp, Jr
b. 18 Nov 1754 d. Abt 1817
10
Mary Sharp
[1.2.1.3.1.1.5.1.1.1]
b. 12 Dec 1776 d. 1841
10
Ann Sharp
[1.2.1.3.1.1.5.1.1.2]
b. 14 Dec 1781
10
John Sharp
[1.2.1.3.1.1.5.1.1.3]
b. 15 Oct 1785 d. 8 Aug 1853
Mary Hunter
b. 17 Dec 1787 d. 2 Jun 1849
11
Helen Sharp
[1.2.1.3.1.1.5.1.1.3.1]
b. 10 Nov 1808 d. 24 Apr 1866
11
Catherine Sharp
[1.2.1.3.1.1.5.1.1.3.2]
b. 1812 d. Abt 1851
11
Cecelia Sharp
[1.2.1.3.1.1.5.1.1.3.3]
b. 15 Nov 1812 d. Abt 1892
Gibson Condie, Jr
b. 14 Jun 1814 d. 19 Nov 1892
12
Gibson Sharp Condie
[1.2.1.3.1.1.5.1.1.3.3.1]
b. 29 Oct 1845 d. 8 Feb 1936
12
Mary C Condie
[1.2.1.3.1.1.5.1.1.3.3.2]
b. 29 Oct 1845 d. 1 Jul 1922
12
Nathaniel Peter Condie
[1.2.1.3.1.1.5.1.1.3.3.3]
b. 1847 d. 1849
12
Ellen Condie
[1.2.1.3.1.1.5.1.1.3.3.4]
b. 27 Apr 1848 d. 30 Aug 1931
12
Robert Sharp Condie
[1.2.1.3.1.1.5.1.1.3.3.5]
b. 20 Sep 1851 d. 18 Jun 1918
12
Elizabeth Ann Condie
[1.2.1.3.1.1.5.1.1.3.3.6]
b. 8 Jul 1853 d. 9 Oct 1945
12
Peter Sharp Condie
[1.2.1.3.1.1.5.1.1.3.3.7]
b. 3 Apr 1855 d. 26 Feb 1939
12
Thomas Sharp Condie
[1.2.1.3.1.1.5.1.1.3.3.8]
b. 20 Jun 1857 d. 3 Feb 1951 [
=>
]
11
Rebecca Sharp
[1.2.1.3.1.1.5.1.1.3.4]
b. Abt 1814
11
Son Sharp
[1.2.1.3.1.1.5.1.1.3.5]
b. Abt 1817
11
Son Sharp
[1.2.1.3.1.1.5.1.1.3.6]
b. Abt 1818
11
John Sharp
[1.2.1.3.1.1.5.1.1.3.7]
b. 9 Nov 1820 d. 23 Dec 1891
11
Agnes Nancy Sharp
[1.2.1.3.1.1.5.1.1.3.8]
b. 4 Jan 1823 d. 15 Oct 1902
11
Margaret Sharp
[1.2.1.3.1.1.5.1.1.3.9]
b. Abt 1825 d. Not Needed
11
Adam Sharp
[1.2.1.3.1.1.5.1.1.3.10]
b. 18 Oct 1827 d. 8 Mar 1890
11
Joseph Sharp
[1.2.1.3.1.1.5.1.1.3.11]
b. 8 Jul 1830 d. 7 Sep 1864
10
Cecilia Sharp
[1.2.1.3.1.1.5.1.1.4]
b. 24 Jul 1787 d. 19 Dec 1872
10
Helen Sharp
[1.2.1.3.1.1.5.1.1.5]
b. 5 May 1789
10
Joseph Sharp
[1.2.1.3.1.1.5.1.1.6]
b. 18 Oct 1791 d. 1850
10
William Sharp
[1.2.1.3.1.1.5.1.1.7]
b. 4 Jul 1793 d. Abt 1862
Elizabeth Patterson
b. 18 Apr 1791 d. 9 Sep 1851
11
Thomas Paterson Sharp
[1.2.1.3.1.1.5.1.1.7.1]
b. 13 Sep 1829 d. 21 Aug 1851
11
Robert Paterson Sharp
[1.2.1.3.1.1.5.1.1.7.2]
b. 20 Aug 1831
11
Mary Paterson Sharp
[1.2.1.3.1.1.5.1.1.7.3]
b. 19 Nov 1833 d. 4 Mar 1911
Adam Duncan
b. 5 Oct 1831 d. 18 Nov 1909
12
James Duncan
[1.2.1.3.1.1.5.1.1.7.3.1]
b. 1855 d. 3 Mar 1922 [
=>
]
12
T William Duncan
[1.2.1.3.1.1.5.1.1.7.3.2]
b. 1857 d. 1912
12
Mary Duncan
[1.2.1.3.1.1.5.1.1.7.3.3]
b. 1860 [
=>
]
12
George McDougal Duncan
[1.2.1.3.1.1.5.1.1.7.3.4]
b. Oct 1861 d. 22 Aug 1922 [
=>
]
12
Elizabeth Duncan
[1.2.1.3.1.1.5.1.1.7.3.5]
b. Nov 1863 d. 19 Oct 1940 [
=>
]
12
Etta Duncan
[1.2.1.3.1.1.5.1.1.7.3.6]
b. 13 Nov 1869 d. 23 Apr 1894 [
=>
]
9
Andrew Russell
[1.2.1.3.1.1.5.1.2]
b. 1757
9
Helen Russell
[1.2.1.3.1.1.5.1.3]
b. 1759
9
Rebecca Russell
[1.2.1.3.1.1.5.1.4]
b. 8 Feb 1762
8
John Russell
[1.2.1.3.1.1.5.2]
b. 29 Apr 1733
8
Margaret Russell
[1.2.1.3.1.1.5.3]
b. 18 Jul 1734
8
Robert Russell
[1.2.1.3.1.1.5.4]
b. 27 Feb 1737
8
Henry Russell
[1.2.1.3.1.1.5.5]
b. 14 Jan 1738
8
Jean Russell
[1.2.1.3.1.1.5.6]
b. 8 Feb 1740
8
James Russell
[1.2.1.3.1.1.5.7]
b. 21 Jun 1745
7
Jean Gardner
[1.2.1.3.1.1.6]
b. Abt 1708
7
Isabell Gardner
[1.2.1.3.1.1.7]
b. Abt 1709
7
Patrick Gardner
[1.2.1.3.1.1.8]
b. 18 Feb 1711
6
Isobell Peter
[1.2.1.3.1.2]
b. 1673
6
Margaret Peter
[1.2.1.3.1.3]
c. 17 Mar 1656
6
John Peter
[1.2.1.3.1.4]
c. 5 May 1660
4
Elizabeth Erskine
[1.2.1.4]
b. 1617
3
Hannah Browne
[1.2.2]
b. Abt 1605
2
Thomas Browne
[1.3]
b. Abt 1577
2
Ambrose Browne
[1.4]
b. 10 Jan 1580
2
Peter Browne
[1.5]
b. Abt 1582 bur. 1633
2
Sarah Browne
[1.6]
b. Abt 1584 d. 23 Mar 1624