Home Page
|
What's New
|
Photos
|
Histories
|
Headstones
|
Reports
|
Surnames
Search
First Name:
Last Name:
Home
Search
Login
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
What's New
Most Wanted
Reports
Dates
Calendar
Cemeteries
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
All Media
Info
Statistics
Places
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Bookmarks
Contact Us
Print
Bookmark
English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Suomalainen
Svenska
Search
•
Advanced Search
•
Search Families
•
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Margaret Hamilton
Abt 1507 -
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Submit Photo / Doc
Worksheet
Family
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Margaret Hamilton
[1]
b. Abt 1507
Andrew Stewart, 2nd Lord Avondale, 1st Lord Ochiltree
b. 1490 d. 1548
2
Andrew Stewart, 2nd Lord Ochiltree
[1.1]
b. 1521 d. 21 Mar 1601
2
Isobel Stewart
[1.2]
b. 1525
2
Andrew Stewart, 2nd Lord Ochiltree
[1.3]
b. Abt 1527 d. 9 Sep 1513
Margaret Stewart
b. 1552 d. 1 Jan 1627
3
Janet Stewart
[1.3.1]
b. 1566 d. 1627
Gilbert Kennedy
b. 1569 d. 11 Dec 1601
4
Mary Kennedy
[1.3.1.1]
b. 1586
4
John Kennedy
[1.3.1.2]
b. 1588 d. 4 Apr 1668
4
Isabelle Kennedy
[1.3.1.3]
b. 1590
4
Colonel Gilbert Kennedy
[1.3.1.4]
b. 7 Nov 1593 d. 30 Aug 1627
Isabel Campbell
b. Abt 1592 d. 1663
5
Thomas Kennedy
[1.3.1.4.1]
b. 1603
5
Gilbert Kennedy
[1.3.1.4.2]
b. 1620 d. 6 Feb 1687
Lady Margaret Glames
b. 1629
6
Robert Kennedy
[1.3.1.4.2.1]
b. Abt 1650
6
Gilbert Kennedy
[1.3.1.4.2.2]
b. Abt 1651 d. 6 Feb 1688
6
Reverend Thomas Kennedy
[1.3.1.4.2.3]
b. 1665 d. 20 Jan 1716
Mary Sophia Lannigan
b. 1673 d. 1730
7
Andrew Kennedy
[1.3.1.4.2.3.1]
b. 1690 d. 1778
7
Reverend William Kennedy
[1.3.1.4.2.3.2]
b. 17 Dec 1695 d. 26 Mar 1776
7
John Kennedy
[1.3.1.4.2.3.3]
b. 1697 d. 22 Jun 1761
7
Reverend Thomas Kennedy
[1.3.1.4.2.3.4]
b. Abt 1699
7
Reverend John Kennedy
[1.3.1.4.2.3.5]
b. 1700
7
Thomas Kennedy
[1.3.1.4.2.3.6]
b. 1703 d. 1788
Rose Elizabeth Davis
b. 1706 d. 1790
8
John Gilbert Kennedy
[1.3.1.4.2.3.6.1]
b. 1740 d. 29 Oct 1803
Bridget Lily Swallow
b. 1742 d. 17 Jul 1774
9
Patrick I Kennedy
[1.3.1.4.2.3.6.1.1]
b. 1760 d. 1824
9
James Kennedy
[1.3.1.4.2.3.6.1.2]
b. 1760 d. 19 Apr 1809
9
Gilbert Kennedy
[1.3.1.4.2.3.6.1.3]
b. 1766 d. 15 Feb 1851
9
Mary Kennedy
[1.3.1.4.2.3.6.1.4]
b. 8 Jun 1766
9
John Kennedy
[1.3.1.4.2.3.6.1.5]
b. 1769 d. 17 Feb 1836
9
James Kennedy
[1.3.1.4.2.3.6.1.6]
b. 1770 d. 1835
Mary Joanna Davis
b. 1779 d. 16 Feb 1835
10
John Kennedy
[1.3.1.4.2.3.6.1.6.1]
b. 1804 d. 1864
10
James Kennedy, Jr
[1.3.1.4.2.3.6.1.6.2]
b. 1816 d. 1881
10
Mary Kennedy
[1.3.1.4.2.3.6.1.6.3]
b. 1820 d. 1898
10
Patrick Kennedy
[1.3.1.4.2.3.6.1.6.4]
b. 16 Feb 1823 d. 22 Nov 1858
Bridget Murphy
b. 1821 d. 20 Dec 1888
11
Mary L Kennedy
[1.3.1.4.2.3.6.1.6.4.1]
b. 9 Aug 1851 d. 7 Mar 1926
11
Joanna L Kennedy
[1.3.1.4.2.3.6.1.6.4.2]
b. 27 Nov 1852 d. 23 Feb 1926
11
John Kennedy
[1.3.1.4.2.3.6.1.6.4.3]
b. 4 Jan 1854 d. 24 Sep 1855
11
Margaret M Kennedy
[1.3.1.4.2.3.6.1.6.4.4]
b. 18 Jul 1855 d. 2 Apr 1929
11
Patrick Joseph Kennedy
[1.3.1.4.2.3.6.1.6.4.5]
b. 14 Jan 1858 d. 18 May 1929
Mary Augusta Hickey
b. 6 Dec 1857 d. 20 May 1923
12
Joseph Patrick Kennedy
[1.3.1.4.2.3.6.1.6.4.5.1]
b. 6 Sep 1888 d. 18 Nov 1969 [
=>
]
12
Francis Benedict Kennedy
[1.3.1.4.2.3.6.1.6.4.5.2]
b. 11 Mar 1891 d. 15 Jun 1892
12
Mary Loretta Kennedy
[1.3.1.4.2.3.6.1.6.4.5.3]
b. 6 Aug 1892 d. 18 Nov 1972
12
Margaret Louise Kennedy
[1.3.1.4.2.3.6.1.6.4.5.4]
b. 22 Oct 1898 d. 11 Nov 1974
11
Mary Jane Kennedy
[1.3.1.4.2.3.6.1.6.4.6]
b. 3 Jan 1864 d. 7 Aug 1869
10
William Kennedy
[1.3.1.4.2.3.6.1.6.5]
b. 15 Mar 1826 d. 19 Dec 1900
9
Mary Kennedy
[1.3.1.4.2.3.6.1.7]
b. 1773
5
Margaret Kennedy
[1.3.1.4.3]
b. 1624 d. 22 Jul 1689
5
Reverend Hugh Thomas Kennedy
[1.3.1.4.4]
b. 1626 d. 26 Jun 1685
5
Jean Kennedy
[1.3.1.4.5]
b. Abt 1627 d. 1700
5
Jane Kennedy
[1.3.1.4.6]
b. 1628 d. 22 Jul 1689
5
Katherine Kennedy
[1.3.1.4.7]
b. 1630
4
Thomas I Kennedy
[1.3.1.5]
b. 1595
4
Margaret Kennedy
[1.3.1.6]
b. 1595
4
John Kennedy
[1.3.1.7]
b. Abt 1602
4
Mary Kennedy
[1.3.1.8]
b. 1615
4
Isabelle Kennedy
[1.3.1.9]
b. 1690 d. 1790
3
Marjorie Stewart
[1.3.2]
b. Abt 1568 d. 25 Nov 1607
William Bruce
b. 1563 d. 1630
4
Robert Bruce
[1.3.2.1]
b. 1590 d. Mar 1636
4
Elizabeth Elspet Bruce
[1.3.2.2]
b. 1591
4
John Bruce
[1.3.2.3]
b. Abt 1592
4
Susanna Bruce
[1.3.2.4]
b. 1594
4
Grizell Bruce
[1.3.2.5]
b. Abt 1598
2
John Stewart, 3rd Earl of Buchan
[1.4]
b. 1528 d. 10 Sep 1547
2
Walter Stewart
[1.5]
b. Abt 1530
2
Margaret Stewart
[1.6]
b. 1540 d. 1612
Reverend John Knox
b. Abt 1513 d. 24 Nov 1572
3
John Knox
[1.6.1]
b. Abt 1566
3
Margaret Knox
[1.6.2]
b. 1567 d. 24 May 1625
3
Elizabeth Knox
[1.6.3]
b. 28 Apr 1572 d. 1 Aug 1625
Reverend John Welsh
b. 1556 d. 2 Apr 1622
4
Sara Welsh
[1.6.3.1]
b. Abt 1592
4
Nathaniel Welsh
[1.6.3.2]
b. 1594
4
John Welsh
[1.6.3.3]
b. 12 Jul 1600 d. 2 Mar 1683
Anne Elizabeth Grosse
b. Abt 1616 d. 15 Feb 1667
5
Johnathan McTarre Welsh
[1.6.3.3.1]
b. 1636 d. 9 Jan 1681
Mary Damaris Wyatt
b. 1641 d. 1693
6
Elizabeth Welch
[1.6.3.3.1.1]
b. 1667 d. 1712
6
Sarah Welsh
[1.6.3.3.1.2]
b. 1674 d. 16 Feb 1733
John Giles
b. 7 Jan 1670 d. 6 Nov 1725
7
Sophia Giles
[1.6.3.3.1.2.1]
b. 1695 d. 14 Sep 1723
7
John Giles
[1.6.3.3.1.2.2]
b. 1700 d. 1731
7
Elizabeth Giles
[1.6.3.3.1.2.3]
b. 1703
7
Jacob Giles
[1.6.3.3.1.2.4]
b. Abt 1717 d. 13 Dec 1780
Johanna Phillips
b. 28 Mar 1720 d. 14 Mar 1805
8
Jacob Giles
[1.6.3.3.1.2.4.1]
b. 15 Mar 1753 d. 17 Apr 1783
8
Elizabeth Giles
[1.6.3.3.1.2.4.2]
b. 8 Jun 1747
8
Ebenezer Thomas Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3]
b. 2 Dec 1749 d. 30 Oct 1798
E Marthaw
b. 2 Dec 1749 d. 8 Apr 1786
9
Johanna Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.1]
b. 1 Oct 1771
9
Jacob Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.2]
b. 23 Mar 1774 d. Bef 1776
9
Jacob Washington Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.3]
b. 26 Jan 1776
9
Joseph Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4]
b. 5 Apr 1778 d. 21 Nov 1858
Jane Moore
c. 2 Feb 1790 d. 6 Jul 1882
10
Ann Eliza Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.1]
b. Abt 1829
10
Emily Miller Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.2]
b. Abt 1831
10
Ebenezer Thomas Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.3]
b. 1838 d. 7 Aug 1904
10
Francina Jane Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.4]
b. Abt 1838
10
Joseph Sinkler Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5]
b. 5 Apr 1833 d. 5 Nov 1921
Sarah Huntsman
b. 3 Jun 1841 d. 5 Apr 1881
11
Joseph Riley Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.1]
b. 8 Oct 1860 d. 22 Oct 1924
Polly Frances Harmon
b. 4 Mar 1864 d. 15 Oct 1944
12
Elmeda Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.1.1]
b. 6 Aug 1883 d. 28 Apr 1969 [
=>
]
12
Dennis Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.1.2]
b. 17 Aug 1886 d. 20 Apr 1969 [
=>
]
12
Shirley Robert Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.1.3]
b. 17 Feb 1898 d. 13 Jun 1991 [
=>
]
12
Mabel Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.1.4]
b. 13 Jan 1893 d. 7 Aug 1990
12
Donald Franklin Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.1.5]
b. 14 Mar 1905 d. 20 Apr 1963 [
=>
]
12
Helen Jeanette Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.1.6]
b. 22 Nov 1907 d. 20 Aug 1975
11
Mary Maranda Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.2]
b. 16 Jan 1862 d. 8 Jun 1947
David Turner
b. 14 Nov 1853 d. 30 Mar 1929
12
Rosa Marilla Turner
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.2.1]
b. 5 Sep 1880 d. 19 Jul 1882
12
Sarah Pearl Turner
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.2.2]
b. 22 Dec 1881 d. 4 Jun 1978
12
David Sinkler Turner
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.2.3]
b. 27 Nov 1883 d. 15 May 1931 [
=>
]
12
Collier Giles Turner
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.2.4]
b. 25 Aug 1885 d. 9 Jan 1959 [
=>
]
12
Zella June Turner
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.2.5]
b. 21 Oct 1889 d. 12 Feb 1961 [
=>
]
12
Ormus Franklin Turner
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.2.6]
b. 28 Oct 1891 d. 3 Jul 1980 [
=>
]
12
Emily Melissa Turner
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.2.7]
b. 24 Jun 1895 d. 21 Jul 1986 [
=>
]
12
Sylvia Manilla Turner
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.2.8]
b. 24 Aug 1898 d. 22 Dec 1988 [
=>
]
12
Jesse Reese Turner
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.2.9]
b. 30 Jan 1904 d. 26 Nov 1948
11
James Freeman Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.3]
b. 23 Nov 1863 d. 26 Jan 1953
Judith Teressa Stringham
b. 13 May 1867 d. 16 Mar 1935
12
James Remus Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.3.1]
b. 24 Apr 1886 d. 7 Feb 1956
12
Elda Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.3.2]
b. 4 Dec 1888 d. 11 Sep 1973 [
=>
]
12
Loren Leo Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.3.3]
b. 24 Jul 1890 d. Nov 1920 [
=>
]
12
Son Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.3.4]
b. 3 Jul 1892 d. 4 Jul 1892
12
Joseph Clinton Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.3.5]
b. 26 Feb 1894 d. 21 Mar 1973
12
Tessie Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.3.6]
b. 22 Mar 1896 d. 17 Sep 1996 [
=>
]
12
Sarah Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.3.7]
b. 12 Jan 1898 d. 12 Jan 1898
12
Jed Stringham Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.3.8]
b. 30 Nov 1898 d. 16 Jun 1980 [
=>
]
12
Riley Newell Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.3.9]
b. 1 Jun 1901 d. 14 Jun 1932
12
Farren Young Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.3.10]
b. 11 Aug 1903 d. 2 Jan 1990 [
=>
]
12
Flora Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.3.11]
b. 9 Aug 1905 d. 11 May 1987 [
=>
]
12
Vivian Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.3.12]
b. 13 Apr 1908 d. 14 May 1995 [
=>
]
12
Dillon Dee Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.3.13]
b. 2 Mar 1910 d. 24 Feb 1994
11
Sarah Jane Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.4]
b. 14 Sep 1865 d. 13 Dec 1966
Solomon Abraham Sprague
b. 18 Aug 1859 d. 21 Nov 1930
12
Karl Giles Sprague
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.4.1]
b. 17 Mar 1888 d. 22 Jan 1958 [
=>
]
12
Alta Sprague
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.4.2]
b. 22 Nov 1889 d. 15 Jul 1972 [
=>
]
12
Clair Dee Sprague
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.4.3]
b. 8 Mar 1893 d. 22 Jun 1957 [
=>
]
12
Evelyn Sprague
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.4.4]
b. 6 Feb 1897 d. 28 Feb 1972 [
=>
]
12
Celestine Sprague
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.4.5]
b. 14 Sep 1898 d. 17 Jan 1962 [
=>
]
Nicholas Albert Farry
b. 1865 d. Abt 1921
12
Joseph Leroy Farry
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.4.6]
b. 13 Jan 1906 d. 30 Oct 1979
11
Emily Ann Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.5]
b. 23 Mar 1867 d. 15 Apr 1949
David Daniel McKee
b. 28 Jan 1859 d. 20 Feb 1946
12
Dora McKee
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.5.1]
b. 18 Oct 1887 d. 5 Jan 1890
12
Angus Vorda McKee
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.5.2]
b. 4 Aug 1890 d. 14 Feb 1972 [
=>
]
12
Ida Lorene McKee
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.5.3]
b. 28 May 1893 d. 28 Nov 1893
12
Effie McKee
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.5.4]
b. 7 Apr 1895 d. 1 Sep 1957 [
=>
]
12
Chloe McKee
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.5.5]
b. 28 Dec 1897 d. 19 Mar 1963 [
=>
]
12
Eva Louise McKee
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.5.6]
b. 2 Nov 1900 d. 7 May 1935 [
=>
]
12
Burton David McKee
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.5.7]
b. 3 Oct 1903 d. 5 Feb 1991 [
=>
]
12
Riley LaVaughn Mckee
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.5.8]
b. 2 Jun 1906 d. 19 Sep 1919
12
Florence McKee
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.5.9]
b. 2 Dec 1908 d. 3 Jun 1993 [
=>
]
11
Jesse Huntsman Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.6]
b. 31 Dec 1868 d. 20 Nov 1954
Emeline Carling
b. 16 Sep 1870 d. 21 Jul 1911
12
Hazel Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.6.1]
b. 4 Sep 1891 d. 2 Dec 1972 [
=>
]
12
Annie Lee Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.6.2]
b. 27 Jan 1893 d. 8 Mar 1965 [
=>
]
12
Maggie Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.6.3]
b. 9 Dec 1895 d. 13 Mar 1985 [
=>
]
12
Jesse Herbert Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.6.4]
b. 2 Dec 1898 d. 5 Mar 1973 [
=>
]
12
Valetta Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.6.5]
b. 22 May 1901 d. 30 Dec 1987 [
=>
]
12
Robert Carling Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.6.6]
b. 23 Feb 1903 d. 21 Jul 1980 [
=>
]
12
Forest LeRoy Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.6.7]
b. 7 Jul 1906 d. 24 Apr 1997 [
=>
]
12
Roma Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.6.8]
b. 29 Jul 1909 d. 25 Sep 1909
12
Joseph Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.6.9]
b. 21 Jul 1911 d. 3 May 2002 [
=>
]
Alice Evelyn Rogers
b. 1 Sep 1875 d. 10 Feb 1961
12
Delores Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.6.10]
b. 28 Oct 1936 d. 21 Jul 2017
12
Joy Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.6.11]
b. 1 Jun 1938 d. 16 Aug 2014
11
Almeda Artiamissa Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.7]
b. 1 Nov 1870 d. 7 Aug 1950
Joseph G Nelson
b. 10 Mar 1864 d. 5 Dec 1950
12
Zersia Mae Nelson
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.7.1]
b. 30 May 1889 d. 19 Oct 1931
12
Joseph Lynn Nelson
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.7.2]
b. 8 Dec 1891 d. 3 Oct 1956 [
=>
]
12
Marta Almeda Nelson
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.7.3]
b. 22 Feb 1894 d. 23 May 1945 [
=>
]
12
Jennie Giles Nelson
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.7.4]
b. 22 Feb 1896 d. 27 Dec 1974 [
=>
]
12
Ephraim Benson Nelson
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.7.5]
b. 2 Aug 1898 d. 3 Jul 1982 [
=>
]
12
Emma Giles Nelson
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.7.6]
b. 17 Aug 1902 d. 5 Feb 1968 [
=>
]
12
Don Giles Nelson
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.7.7]
b. 8 Sep 1904 d. 25 Jan 1985 [
=>
]
12
Scott Giles Nelson
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.7.8]
b. 15 Dec 1905 d. 11 Jan 1997 [
=>
]
12
Jesse Giles Nelson
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.7.9]
b. 10 Jun 1908 d. 2 Jun 1981 [
=>
]
12
Anna Giles Nelson
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.7.10]
b. 10 Jun 1908 d. 16 Jun 1994 [
=>
]
12
Karl Giles Nelson
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.7.11]
b. 18 Feb 1911 d. 2 Feb 1997 [
=>
]
12
John Aaron Nelson
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.7.12]
b. 17 Jan 1916 d. 11 Sep 2005 [
=>
]
11
John Thomas Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.8]
b. 30 Jan 1873 d. 8 Dec 1939
Lucy Armina Wilson
b. 19 Mar 1877 d. 1 Jul 1948
12
Frank Elwin Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.8.1]
b. 7 Sep 1898 d. 31 Dec 1899
12
Claud Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.8.2]
b. 13 Dec 1899 d. 29 Jan 1975
12
Elva Jeanne Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.8.3]
b. 14 Aug 1903 d. 26 Dec 2002
12
Joseph Clayton Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.8.4]
b. 11 Jan 1906 d. 20 May 1980
12
Dolly Kathleen Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.8.5]
b. 11 Jul 1908 d. 24 Mar 1979 [
=>
]
12
Earl Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.8.6]
b. 18 Jan 1911 d. 27 Nov 1990 [
=>
]
12
Perry Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.8.7]
b. 1 Sep 1915 d. 7 Jul 1977 [
=>
]
12
Madge Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.8.8]
b. 13 Jun 1918 d. 26 Sep 2007 [
=>
]
11
William Sinkler Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.9]
b. 6 Aug 1874 d. Feb 1875
11
Lorinda Melissa Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.10]
b. 1 Oct 1875 d. 31 Jan 1944
Robert Fergus Miller
b. 17 Sep 1875 d. 29 Jun 1945
12
Haven Giles Miller
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.10.1]
b. 30 Nov 1897 d. 16 Mar 1969
12
Robert Eugene Miller
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.10.2]
b. 12 Jun 1903 d. 28 Jul 1991 [
=>
]
12
Harold Giles Miller
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.10.3]
b. 15 Sep 1910 d. 19 Nov 1999 [
=>
]
12
Mary Miller
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.10.4]
b. 26 Sep 1912 d. 30 Oct 1916
12
Florence Louise Miller
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.10.5]
b. 5 Oct 1916 d. 22 Jul 2006 [
=>
]
11
Salena Marilla Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.11]
b. 22 Oct 1877 d. 16 Feb 1969
William Southern
b. 7 Aug 1874 d. 4 Jun 1950
12
Sabra Giles Southern
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.11.1]
b. 16 Sep 1898 d. 5 May 1988 [
=>
]
12
Bernez Aramenta Southern
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.11.2]
b. 21 Jul 1900 d. 26 Nov 1911
12
Babette Zee Southern
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.11.3]
b. 17 Mar 1906 d. 29 Apr 1960
12
Joseph Kay Southern
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.11.4]
b. 11 Aug 1911 d. 15 Jan 1943 [
=>
]
12
Kalta Romaine Southern
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.11.5]
b. 20 Aug 1913 d. 6 Mar 1986 [
=>
]
12
Eve Lynn Blanch Southern
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.11.6]
b. 16 Sep 1918 d. 16 Dec 2009 [
=>
]
11
Eva May Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.12]
b. 27 Dec 1878 d. 1879
11
Jacob Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.13]
b. 5 Apr 1881 d. 1882
Ann Elizabeth Carling
b. 23 May 1865 d. 12 Mar 1925
11
Lou Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.14]
b. 20 Nov 1884 d. 22 Sep 1959
James William Frampton, Jr
b. 6 Jan 1882 d. 29 Aug 1959
12
William Vernon Frampton
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.14.1]
b. 1 Dec 1904 d. 11 Jul 1989 [
=>
]
12
Lois Frampton
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.14.2]
b. 15 Jul 1907 d. 20 May 1999 [
=>
]
12
Giles L Frampton
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.14.3]
b. 19 Jan 1910 d. 7 Jan 1991 [
=>
]
12
Dell Frampton
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.14.4]
b. 9 Jul 1913 d. 17 Mar 2008
12
Myrl Frampton
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.14.5]
b. 17 Jan 1917 d. 11 Oct 1993
12
Kathlyn Frampton
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.14.6]
b. 8 Mar 1920 d. 14 Nov 2003 [
=>
]
12
Bertis Elroy Frampton
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.14.7]
b. 24 Feb 1924 d. 21 Jan 2000 [
=>
]
11
Laura Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.15]
b. 10 Nov 1887 d. 22 Jan 1926
Ernest Brough
b. 10 Feb 1890 d. 6 Jun 1967
12
Enid Brough
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.15.1]
b. 7 Aug 1916 d. 18 Mar 2007
12
Joseph Arnold Brough
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.15.2]
b. 25 Jul 1918 d. 18 Aug 1998
12
Ernest Rulon Brough
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.15.3]
b. 30 Dec 1911 d. 2 Jul 2003 [
=>
]
12
John Henry Brough
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.15.4]
b. 26 May 1914 d. 23 Jul 1974
12
Laura Elizabeth Brough
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.15.5]
b. 2 Sep 1910 d. 2 Sep 1910
12
Madge Brough
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.15.6]
b. 5 Nov 1921 d. 16 Oct 2013
11
Florence Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.16]
b. 21 Apr 1890 d. 9 Dec 1965
Ray Mervin Brough
b. 4 May 1886 d. 26 Jan 1953
12
Ray Giles Brough
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.16.1]
b. 8 Feb 1911 d. 5 Jan 1914
12
Grant Thorwell Brough
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.16.2]
b. 12 Apr 1913 d. 15 Jun 2006
12
Thomas Grover Brough
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.16.3]
b. 5 Aug 1916 d. 14 Aug 1988 [
=>
]
12
Florence Nan Brough
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.16.4]
b. 20 Aug 1918 d. 2 Feb 2008 [
=>
]
11
Grover Abraham Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.17]
b. 10 Sep 1892 d. 26 Nov 1974
Mabel Elizabeth James
b. 10 Nov 1893 d. 14 May 1981
12
Helen Audrienne Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.17.1]
b. 11 Aug 1922 d. 22 Sep 1989
12
Grover Abraham Giles, Jr
[1.6.3.3.1.2.4.3.4.5.17.2]
b. 15 Mar 1929 d. 26 Oct 1952
9
Susanna Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.5]
b. 18 Jul 1775
9
Nathaniel Giles
[1.6.3.3.1.2.4.3.6]
b. 5 Dec 1778
8
Sarah Giles
[1.6.3.3.1.2.4.4]
b. Abt 1751 d. 19 Feb 1784
8
Thomas Giles
[1.6.3.3.1.2.4.5]
b. 25 Dec 1754
8
Aquilla Giles
[1.6.3.3.1.2.4.6]
b. 29 Aug 1757 d. 8 Apr 1822
8
Edward Giles
[1.6.3.3.1.2.4.7]
b. 24 Apr 1759 d. 10 Mar 1783
8
Johannah Giles
[1.6.3.3.1.2.4.8]
b. 20 May 1761 d. 19 Feb 1782
7
Sarah Prudence Giles
[1.6.3.3.1.2.5]
b. 6 Mar 1722 d. 1810
6
Benjamim Welch
[1.6.3.3.1.3]
b. 1675 d. 1727
6
Mary Welch
[1.6.3.3.1.4]
b. 1677 d. 20 Apr 1726
6
Damaris Welch
[1.6.3.3.1.5]
b. Abt 1680
Thomas Stockett
b. 1646
7
Eleanor Stockett
[1.6.3.3.1.5.1]
b. 8 Dec 1693
6
Robert Welch
[1.6.3.3.1.6]
b. Abt 1682 d. 1762
5
Henry Welsh
[1.6.3.3.2]
b. 1642 d. 1683
5
Helen Welsh
[1.6.3.3.3]
b. 1645 d. 1697
4
William Welsh
[1.6.3.4]
b. Abt 1602 d. 1622
4
Luyse Welsh
[1.6.3.5]
b. 20 May 1613 d. 1650