Home Page
|
What's New
|
Photos
|
Histories
|
Headstones
|
Reports
|
Surnames
Search
First Name:
Last Name:
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Suomalainen
Svenska
Agnes Petley
Abt 1482 -
Submit Photo / Document
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Submit Photo / Doc
Worksheet
Family
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Agnes Petley
[1]
b. Abt 1482
John Manning
b. Abt 1481 d. 10 May 1542
2
Henry Manning
[1.1]
b. Abt 1510 d. 1582
Catherine Kirkner
b. 1535 d. 4 Feb 1594
3
Henry Manning
[1.1.1]
b. 29 May 1557 d. 14 Jun 1614
3
Anna Manning
[1.1.2]
b. 3 Nov 1558 d. Bef 1584
3
Mildred Fortune Manning
[1.1.3]
b. 1559 d. 1 Sep 1627
3
Margaret Manning
[1.1.4]
b. 30 May 1559 d. 14 Dec 1643
3
Katheryn Manning
[1.1.5]
b. 1562 d. Abt 1667
3
Dorothea Manning
[1.1.6]
b. 1568
2
George Manning
[1.2]
b. 1520 d. 8 May 1582
Joan Wallis
b. 1524 d. 5 Jun 1582
3
Anne Manning
[1.2.1]
c. 22 Oct 1545
+
Thomas Lambert
b. Abt 1535 d. 1580
3
Joane Manning
[1.2.2]
c. 30 Jan 1546
Henry Welsh
b. 1546
4
Henry Welsh
[1.2.2.1]
b. 1577
3
Katharine Manning
[1.2.3]
b. 3 Apr 1548 bur. 30 Jun 1596
Hugh Underhill
b. 1519 d. 1593
4
Thomas "Hugh" Underhill
[1.2.3.1]
b. Abt 1566 d. 1591
4
George Underhill
[1.2.3.2]
b. Abt 1568 d. 1627
+
Richard Goodman
d. 24 Nov 1611
3
Rose Manning
[1.2.4]
b. Abt 1551 d. 6 Aug 1554
3
Peter Manning
[1.2.5]
c. 6 Aug 1553 bur. 10 Dec 1621
Elizabeth Verezelini
b. Abt 1555 d. Feb 1634
4
Jacob Manning
[1.2.5.1]
b. Abt 1580
4
Nicholas Manning
[1.2.5.2]
b. Abt 1582
4
Bartholomen Manning
[1.2.5.3]
b. Abt 1585
4
Henery Manning
[1.2.5.4]
b. 1588 d. Bef 8 Sep 1632
4
Percivall Manning
[1.2.5.5]
c. 25 Oct 1590
4
Peter Manning
[1.2.5.6]
b. Abt 1593
4
George Manning
[1.2.5.7]
b. Abt 1600
4
Edward Manning
[1.2.5.8]
c. 28 Dec 1602 bur. 10 Jun 1621
4
Agnes Manning
[1.2.5.9]
b. Abt 1604
4
Elizabeth Manning
[1.2.5.10]
b. Abt 1606
3
Elizabeth Manning
[1.2.6]
c. 6 Aug 1554
+
Griffin Green
b. Abt 1550
3
John Manning
[1.2.7]
b. 20 Jun 1555 d. Aft 1582
3
George Manning
[1.2.8]
b. 20 Jun 1555 d. 20 Jun 1555
3
Nicholas Manning
[1.2.9]
c. 9 Jul 1557 d. 28 Oct 1557
3
Dorothy Manning
[1.2.10]
b. 3 Oct 1558
John Webb
b. Abt 1554 d. 1 Feb 1625
4
Peter Webb
[1.2.10.1]
b. Abt 1578
4
Peter Webb
[1.2.10.2]
b. Abt 1584
4
John Webb
[1.2.10.3]
b. Abt 1586
4
Ann Webb
[1.2.10.4]
b. Abt 1588
4
Jane Webb
[1.2.10.5]
b. Abt 1590
4
John Webb
[1.2.10.6]
b. Abt 1580
4
Oliph Webb
[1.2.10.7]
b. Abt 1582
3
Thomas Manning
[1.2.11]
c. 25 Jan 1561 d. 1594
Miriam Botley
b. Abt 1561 d. 1595
4
Thomas Manning
[1.2.11.1]
b. Sep 1591 d. 28 Nov 1645
3
Phebe Manning
[1.2.12]
b. 1566 d. Abt 1642
James Waters
b. Abt 1575 d. 2 Feb 1617
4
Martha Waters
[1.2.12.1]
b. Abt 1598 bur. 8 Oct 1603
4
Sarah Waters
[1.2.12.2]
b. 30 Nov 1600 d. 1686
4
Phebe Waters
[1.2.12.3]
c. 6 Dec 1602 d. 7 Dec 1603
4
Richard John Waters
[1.2.12.4]
b. 3 Mar 1604 d. 16 Jul 1676
Rejoice Joyce Plasse
b. 1616 d. Abt 1687
5
Sarah Waters
[1.2.12.4.1]
b. 30 Jun 1637 d. 19 May 1700
Joshua Rea
b. Abt 1628 d. 1710
6
Samuel Rea
[1.2.12.4.1.1]
b. Abt 1652 d. Abt 1718
Mary Sheldon
b. 15 Jul 1660 d. 31 Mar 1746
7
Samuel Ray
[1.2.12.4.1.1.1]
b. 12 Mar 1687 d. 2 Sep 1744
7
William Rea
[1.2.12.4.1.1.2]
b. 18 Apr 1691 d. 21 Aug 1693
7
Daughter Rea
[1.2.12.4.1.1.3]
b. Dec 1693
7
Robert Rea
[1.2.12.4.1.1.4]
b. 26 Dec 1695
7
Jonathan Rea
[1.2.12.4.1.1.5]
b. 9 Jul 1697
7
Benjamin Rea
[1.2.12.4.1.1.6]
b. 7 Apr 1699
7
Abel Ray
[1.2.12.4.1.1.7]
b. 6 Jun 1701
7
Elizabeth Rea
[1.2.12.4.1.1.8]
b. 31 Jul 1703
6
Daniel Rea
[1.2.12.4.1.2]
b. 30 Mar 1654 d. 5 Mar 1714
Hepzibah Peabody
b. Abt 1652
7
Lemuel Rea
[1.2.12.4.1.2.1]
b. Abt 1679 d. 1749
7
Jemima Rea
[1.2.12.4.1.2.2]
b. 29 Dec 1680
7
Daniel Rea
[1.2.12.4.1.2.3]
b. 23 Nov 1682 d. 1746
7
Zerubabel Rea
[1.2.12.4.1.2.4]
b. 12 May 1685
7
Elizabeth Rea
[1.2.12.4.1.2.5]
b. 13 Aug 1687 d. 14 Dec 1711
7
Keturah Rea
[1.2.12.4.1.2.6]
b. Abt 1689
6
Rebecca Rea
[1.2.12.4.1.3]
b. 4 Sep 1656 d. 11 Feb 1740
+
John Ballard
b. 17 Jan 1653 d. 18 Dec 1715
6
Sarah Rea
[1.2.12.4.1.4]
b. 10 Nov 1658
Thomas Haynes
b. Abt 1645 d. 25 Sep 1685
7
John Haynes
[1.2.12.4.1.4.1]
b. 14 Apr 1678
7
William Haynes
[1.2.12.4.1.4.2]
b. 25 Aug 1680
7
Sarah Haynes
[1.2.12.4.1.4.3]
b. 31 Oct 1681
7
Joseph Christopher Haynes
[1.2.12.4.1.4.4]
b. 1682 d. 1760
7
Benjamin Haynes
[1.2.12.4.1.4.5]
b. 1685
7
Daniel Haynes
[1.2.12.4.1.4.6]
b. 1687 d. 1689
7
Hannah Haynes
[1.2.12.4.1.4.7]
b. 1689
7
Thomas Haynes
[1.2.12.4.1.4.8]
b. 1690
6
Elizabeth Rea
[1.2.12.4.1.5]
b. 3 Jan 1660
Joseph Gould
b. 15 Jan 1662 d. 1710
7
Sarah Gould
[1.2.12.4.1.5.1]
b. 27 Jun 1688 d. 12 Jul 1688
7
Elizabeth Gould
[1.2.12.4.1.5.2]
b. 27 Jun 1688 d. 12 Jul 1688
7
Daniel Gould
[1.2.12.4.1.5.3]
b. 1 Dec 1691
7
Zerviah Gould
[1.2.12.4.1.5.4]
b. 20 Apr 1694 d. Bef 1741
John Sibley
b. 18 Sep 1687 d. 13 May 1741
8
Ebenezer Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.1]
b. 28 Feb 1717 d. 4 Mar 1790
Abigail Cummings
b. 3 May 1716 d. 27 Sep 1783
9
Stephen Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.1.1]
b. 12 Jul 1741 d. 25 Aug 1828
Thankful Taft
b. 25 May 1745 d. 26 Oct 1837
10
Joel Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.1.1.1]
b. 25 Apr 1766 d. 10 Apr 1839
Lois Louise Woods
b. 24 Jun 1767 d. 21 Nov 1832
11
Amory Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.1.1.1.1]
b. 20 Jun 1792 d. 22 Jun 1849
Caroline Bosworth
b. Abt 1796 d. 13 Jan 1858
12
Martha Elmira Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.1.1.1.1.1]
b. 16 Oct 1839 d. 1 Oct 1920 [
=>
]
11
Josiah Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.1.1.1.2]
b. 1 Apr 1808 d. 7 Dec 1888
Sarah Ann Sophia Crapon
b. 24 Oct 1809 d. 17 May 1858
12
Samuel Hale Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.1.1.1.2.1]
b. 9 Sep 1835 d. 1883 [
=>
]
12
William Crapon Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.1.1.1.2.2]
b. 3 May 1832 d. 17 Apr 1902 [
=>
]
12
Henry Josiah Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.1.1.1.2.3]
b. 19 Nov 1833 d. 25 Jul 1864
12
Sophia Matilda Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.1.1.1.2.4]
b. 16 Oct 1837 d. 29 Oct 1897
12
George Royal Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.1.1.1.2.5]
b. 19 Jul 1839 d. 15 Jul 1895 [
=>
]
12
Fannie Maria Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.1.1.1.2.6]
b. 13 Oct 1841 d. 20 Dec 1842
12
Mary Lois Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.1.1.1.2.7]
b. 3 Sep 1843 d. 23 Feb 1864
12
Alice Marie Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.1.1.1.2.8]
b. 9 Feb 1846 d. 13 Jul 1907
12
Robert Pendelton Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.1.1.1.2.9]
b. Abt 1847 [
=>
]
12
Caroline Crapon Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.1.1.1.2.10]
b. 21 Feb 1850 d. 16 Nov 1858
12
Amory Walter Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.1.1.1.2.11]
b. 19 Jun 1852 d. 28 Jul 1899
12
Josiah Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.1.1.1.2.12]
b. 1866 d. 1879
Emaline Eve
b. 1839
12
John Adam Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.1.1.1.2.13]
b. 1 Sep 1861 d. 26 Mar 1934
12
James Longstreet Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.1.1.1.2.14]
b. 4 Aug 1863 d. 10 Sep 1945 [
=>
]
12
Mary Bones Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.1.1.1.2.15]
b. 29 Mar 1865 d. 22 Jun 1954
12
Emma Josephine Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.1.1.1.2.16]
b. 23 Feb 1867 d. 25 Oct 1957 [
=>
]
10
Lydia Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.1.1.2]
b. 2 Apr 1769 d. 27 Nov 1822
Henry Staples Benson
b. 8 Aug 1770 d. 29 Jul 1821
11
Abigail Benson
[1.2.12.4.1.5.4.1.1.2.1]
b. 31 Mar 1795 d. 10 Nov 1821
Asa Legg
b. 7 May 1792 d. 15 Nov 1836
12
Charlotte Legg
[1.2.12.4.1.5.4.1.1.2.1.1]
b. 2 May 1818 d. 30 Oct 1900 [
=>
]
12
Lyman Legg
[1.2.12.4.1.5.4.1.1.2.1.2]
b. 3 Sep 1822 d. 1 Sep 1904 [
=>
]
11
Harriet Benson
[1.2.12.4.1.5.4.1.1.2.2]
b. 14 Sep 1796 d. 22 Aug 1852
11
Mellen Benson
[1.2.12.4.1.5.4.1.1.2.3]
b. 14 Jan 1798
Eliza W Farnum
b. 25 Sep 1802 d. 14 Sep 1839
12
Henry Staples Benson
[1.2.12.4.1.5.4.1.1.2.3.1]
b. 17 May 1829
12
Almira Farnum Benson
[1.2.12.4.1.5.4.1.1.2.3.2]
b. 6 Aug 1830 d. 25 Dec 1835
12
James Haskins Benson
[1.2.12.4.1.5.4.1.1.2.3.3]
b. 16 Oct 1833
12
George Everett Benson
[1.2.12.4.1.5.4.1.1.2.3.4]
b. 14 Aug 1837
+
Mary Windsor Peck
b. 21 May 1798
11
Hannah Adaline Benson
[1.2.12.4.1.5.4.1.1.2.4]
b. 12 Aug 1802 d. 19 Jun 1822
11
Rufus Benson
[1.2.12.4.1.5.4.1.1.2.5]
b. 24 Jan 1804 d. 23 Aug 1805
11
Chloe Ann Benson
[1.2.12.4.1.5.4.1.1.2.6]
b. 23 Aug 1806
+
Dan Hill
b. 29 Nov 1796
11
Susan Augusta Benson
[1.2.12.4.1.5.4.1.1.2.7]
b. 9 Oct 1809 d. 25 Jul 1831
Preserved Smith Thayer
b. 9 May 1808
12
Susan Benson Thayer
[1.2.12.4.1.5.4.1.1.2.7.1]
b. 28 Jun 1831 d. 14 Aug 1909
11
Rufus Aldrich Benson
[1.2.12.4.1.5.4.1.1.2.8]
b. 9 Oct 1809
+
Sarah E Buell
11
Stephen Sibley Benson
[1.2.12.4.1.5.4.1.1.2.9]
b. 9 Jan 1810 d. 20 Nov 1869
Elizabeth Richardson Scott
b. 8 Jan 1835 d. 20 Feb 1911
12
Jessie Harriet Benson
[1.2.12.4.1.5.4.1.1.2.9.1]
b. 7 Jun 1860
12
Fred Mellen Benson
[1.2.12.4.1.5.4.1.1.2.9.2]
b. 10 Nov 1862 d. 9 May 1864
12
Susie Adeline Benson
[1.2.12.4.1.5.4.1.1.2.9.3]
b. 6 Aug 1865
9
Ebenezer Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.1.2]
b. 9 Oct 1745
Mary Chase
b. 15 Mar 1741 d. 1784
10
Sarah Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.1.2.1]
b. 19 Dec 1772
10
Lucy Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.1.2.2]
b. 2 Mar 1775
+
Forbes Bond
b. Abt 1773
10
Eunice Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.1.2.3]
b. 1 Mar 1777
10
Elias Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.1.2.4]
b. 8 Aug 1779 d. 1856
Ruth Chase
b. 31 Jan 1780 d. Abt 1858
11
Alonzo Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.1.2.4.1]
b. 14 Jul 1810 d. 16 Mar 1896
Mary Heath
b. 10 Sep 1813 d. 1836
12
Son Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.1.2.4.1.1]
b. 20 Oct 1836 d. 5 Dec 1836
Sarah Ann Heath
b. 10 Apr 1812 d. 1873
12
Daughter Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.1.2.4.1.2]
b. 1838 d. 7 Jul 1838
12
Mary Jane Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.1.2.4.1.3]
b. 17 Nov 1840 d. 15 Feb 1922 [
=>
]
12
Harriet A Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.1.2.4.1.4]
b. 25 Nov 1842 d. 6 Jul 1886 [
=>
]
12
Watson A Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.1.2.4.1.5]
b. 1844 d. 24 Apr 1924 [
=>
]
12
Judson L Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.1.2.4.1.6]
b. Oct 1846 [
=>
]
+
Adeline Colby
b. 10 Jun 1818 d. 18 Mar 1896
10
Ebenezer Sibley, Jr
[1.2.12.4.1.5.4.1.2.5]
b. 18 Jan 1782 d. 15 Mar 1827
Polly B Whipple
b. 16 Jun 1791
11
Lorinda Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.1.2.5.1]
b. 6 Jul 1810
+
Charles Arnold
11
Maria Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.1.2.5.2]
b. 23 Jul 1812
Whitcomb Gray
b. Abt 1804 d. 10 Jan 1888
12
Delia Maria Gray
[1.2.12.4.1.5.4.1.2.5.2.1]
b. 1834
12
Mary Ann Grey
[1.2.12.4.1.5.4.1.2.5.2.2]
c. 20 Mar 1836
11
Polly Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.1.2.5.3]
b. 11 Sep 1814
11
Mary Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.1.2.5.4]
b. 8 Mar 1817 d. 17 Jun 1903
Benjamin Cragin
b. 6 Mar 1814 d. 20 Jan 1896
12
Mary Emma Cragin
[1.2.12.4.1.5.4.1.2.5.4.1]
b. 12 Dec 1839 d. 25 Aug 1924 [
=>
]
12
Maria A Cragin
[1.2.12.4.1.5.4.1.2.5.4.2]
b. 27 Dec 1844
11
Loren Elba Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.1.2.5.5]
b. 3 May 1821
10
Zadock Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.1.2.6]
b. 12 Oct 1785
10
Mary Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.1.2.7]
b. 1 Feb 1789 d. 24 Apr 1844
+
Amos Peirce
b. Abt 1786 d. 22 Dec 1848
9
Abigail Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.1.3]
b. 22 Jan 1747
9
Peter Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.1.4]
b. 16 Sep 1749
9
Mary Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.1.5]
b. 20 Jan 1751
8
Stephen Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.2]
b. 1 Oct 1720
Mrs Sibley
b. Abt 1725
9
Elias Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.2.1]
b. Abt 1745
8
Bethiah Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.3]
b. 2 Oct 1724 d. 1 Jul 1756
Samuel Trask
b. 17 Dec 1721 d. 7 Mar 1790
9
John Trask
[1.2.12.4.1.5.4.3.1]
b. 29 Sep 1744
9
Hannah Trask
[1.2.12.4.1.5.4.3.2]
b. 10 Nov 1746
9
Sarah Trask
[1.2.12.4.1.5.4.3.3]
b. 10 Sep 1753 d. 22 Aug 1830
Major Simon Tenney
b. 13 Sep 1746 d. 14 Aug 1838
10
Major Daniel Tenney
[1.2.12.4.1.5.4.3.3.1]
b. 23 Nov 1773
Betsey Waters
b. 12 Jul 1776 d. 16 Aug 1851
11
Sarah Tenney
[1.2.12.4.1.5.4.3.3.1.1]
b. 6 Oct 1797 d. 13 Apr 1880
Edmond John Mills
b. 17 Aug 1791 d. 11 Sep 1889
12
Wiliam Edmund Mills
[1.2.12.4.1.5.4.3.3.1.1.1]
b. 2 Nov 1825 d. 18 Dec 1914 [
=>
]
12
Nancy Tenney Mills
[1.2.12.4.1.5.4.3.3.1.1.2]
b. 15 Mar 1828 d. 12 Jun 1880 [
=>
]
12
Samuel John Mills
[1.2.12.4.1.5.4.3.3.1.1.3]
b. 17 Nov 1830 d. 23 Jan 1838
12
Son Mills
[1.2.12.4.1.5.4.3.3.1.1.4]
b. 1 Mar 1835 d. 31 Mar 1835
12
Franklin Lewis Mills
[1.2.12.4.1.5.4.3.3.1.1.5]
b. 24 Oct 1836 d. 14 Feb 1918 [
=>
]
12
Sarah Maria Mills
[1.2.12.4.1.5.4.3.3.1.1.6]
b. 18 Aug 1841
11
Sally Tenney
[1.2.12.4.1.5.4.3.3.1.2]
b. 6 Oct 1797
11
Simon Tenney
[1.2.12.4.1.5.4.3.3.1.3]
b. 3 Dec 1799 d. 11 Jun 1856
Nancy Putnam
b. 17 Feb 1800
12
David Tenney
[1.2.12.4.1.5.4.3.3.1.3.1]
b. Abt 1830
12
Daniel Tenney
[1.2.12.4.1.5.4.3.3.1.3.2]
b. 29 Feb 1832 d. 6 Dec 1844
12
George Tenney
[1.2.12.4.1.5.4.3.3.1.3.3]
b. 30 Jan 1837 d. 29 Oct 1839
11
John Waters Tenney
[1.2.12.4.1.5.4.3.3.1.4]
b. 25 Jul 1802 d. 29 Apr 1849
Eliza Tileston Fisher
b. 13 May 1803 d. 21 Aug 1847
12
Edward Waters Tenney
[1.2.12.4.1.5.4.3.3.1.4.1]
b. Aug 1830 [
=>
]
11
Linus Tenney
[1.2.12.4.1.5.4.3.3.1.5]
b. 5 Dec 1804
Sally Elwell
b. 2 Dec 1806
12
Charles Linus Tenney
[1.2.12.4.1.5.4.3.3.1.5.1]
b. 12 Jan 1829 [
=>
]
12
George Franklin Tenney
[1.2.12.4.1.5.4.3.3.1.5.2]
b. 7 Sep 1831 d. 24 Nov 1831
12
James Henry Tenney
[1.2.12.4.1.5.4.3.3.1.5.3]
b. 10 Jun 1838 [
=>
]
11
Nancy Tenney
[1.2.12.4.1.5.4.3.3.1.6]
b. 21 Jan 1808 d. 29 May 1822
11
Danial Austin Tenney
[1.2.12.4.1.5.4.3.3.1.7]
b. 29 Aug 1811 d. 7 Feb 1871
Marietta Margaret Marcy
b. 11 Jun 1811
12
Daniel Austin Tenney
[1.2.12.4.1.5.4.3.3.1.7.1]
b. 15 Oct 1835 [
=>
]
12
Joseph Starks Tenney
[1.2.12.4.1.5.4.3.3.1.7.2]
b. 24 Feb 1838 [
=>
]
12
George Laban Tenney
[1.2.12.4.1.5.4.3.3.1.7.3]
b. 25 Jul 1840
12
Frederick Prescott Tenney
[1.2.12.4.1.5.4.3.3.1.7.4]
b. 6 Jul 1845
12
Frank Herbert Tenney
[1.2.12.4.1.5.4.3.3.1.7.5]
b. 16 Jan 1849 [
=>
]
11
Benjamin Franklin Tenney
[1.2.12.4.1.5.4.3.3.1.8]
b. 28 Oct 1813 d. 26 Oct 1900
Frances Bridges Veagie
b. 7 Mar 1819 d. 24 Oct 1858
12
Joseph Franklin Tenney
[1.2.12.4.1.5.4.3.3.1.8.1]
b. 12 Nov 1838 d. 1878
Mary Bowman Viles
b. 17 Feb 1831
12
Frank Tenney
[1.2.12.4.1.5.4.3.3.1.8.2]
b. 4 Feb 1861
12
Arthur Tenney
[1.2.12.4.1.5.4.3.3.1.8.3]
b. 1 Jun 1863 d. 16 Jun 1866
12
Maud Tenney
[1.2.12.4.1.5.4.3.3.1.8.4]
b. 13 May 1875 d. 30 Jun 1896 [
=>
]
9
Samuel Trask, Jr
[1.2.12.4.1.5.4.3.4]
b. 26 Aug 1749
Ruth Tenney
b. 16 Mar 1753 d. 27 Apr 1789
10
Samuel Trask, III
[1.2.12.4.1.5.4.3.4.1]
b. 10 Dec 1773
10
Simon Trask
[1.2.12.4.1.5.4.3.4.2]
b. 13 Jan 1775
10
Hannah Trask
[1.2.12.4.1.5.4.3.4.3]
b. 4 Feb 1777
10
Stephen Trask
[1.2.12.4.1.5.4.3.4.4]
b. 18 Feb 1779
10
Salley Trask
[1.2.12.4.1.5.4.3.4.5]
b. 17 Jan 1784 d. 5 Feb 1819
Elijah Holman
11
Jonathan Holman
[1.2.12.4.1.5.4.3.4.5.1]
b. 21 Jun 1813 d. 24 Oct 1816
11
Sarah Trask Holman
[1.2.12.4.1.5.4.3.4.5.2]
b. 16 May 1816 d. 8 May 1847
Sherman Hale
b. Abt 1812
12
Anna Hale
[1.2.12.4.1.5.4.3.4.5.2.1]
b. Abt 1838
12
Ann Hale
[1.2.12.4.1.5.4.3.4.5.2.2]
b. 1840
12
Emily Hale
[1.2.12.4.1.5.4.3.4.5.2.3]
b. Jul 1841 d. 2 Nov 1906
12
Anna H Hale
[1.2.12.4.1.5.4.3.4.5.2.4]
b. Feb 1843 d. 5 Jan 1929
12
Sarah Frank Hale
[1.2.12.4.1.5.4.3.4.5.2.5]
b. 16 Dec 1844 d. 30 Oct 1933
12
Charles T H Hale
[1.2.12.4.1.5.4.3.4.5.2.6]
b. 1846
11
Son Holman
[1.2.12.4.1.5.4.3.4.5.3]
b. Abt 1819 d. 23 Feb 1826
Allice Perry
b. Abt 1759
10
Talmon Trask
[1.2.12.4.1.5.4.3.4.6]
c. 6 Oct 1799
10
Danforth Trask
[1.2.12.4.1.5.4.3.4.7]
c. 27 Nov 1801
10
Dexter Trask
[1.2.12.4.1.5.4.3.4.8]
c. 11 Aug 1807
10
Edwin Trask
[1.2.12.4.1.5.4.3.4.9]
c. 29 Sep 1809
10
Angelina Trask
[1.2.12.4.1.5.4.3.4.10]
c. 26 Oct 1811
9
Anne Trask
[1.2.12.4.1.5.4.3.5]
b. 9 Oct 1757
8
Timothy Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4]
b. 2 Nov 1727 d. 6 Dec 1818
Ann Waite
b. 14 Oct 1733 d. 12 Mar 1791
9
John Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.1]
b. 19 May 1757 d. 8 Apr 1837
Betsey Hopkins
b. Abt 1754 d. 1790
10
George Champlin Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.1.1]
b. 1 Apr 1782 d. 31 Jan 1863
+
Mary Smith Easton
b. 24 Jan 1800 d. 20 Jun 1878
9
Timothy Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2]
b. 19 Jun 1754 d. 26 Aug 1829
Mary
b. Abt 1756
10
Timothy Willard Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.1]
b. 11 Sep 1779 d. 11 Mar 1820
Elizabeth Comins
d. 2 Mar 1820
11
William C Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.1.1]
b. 20 Jun 1812
11
Sarah Elizabeth Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.1.2]
b. 2 Jan 1814
11
Mary Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.1.3]
b. 26 Sep 1815
11
Amanda M Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.1.4]
b. 25 Jun 1817
11
Nancy W Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.1.5]
b. 10 Jul 1819
Francis S Putney
b. 20 Oct 1818
12
William Frank Putney
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.1.5.1]
b. 23 Sep 1844 d. 11 Feb 1847
12
Frank Edward Putney
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.1.5.2]
b. 12 Apr 1847 d. Dec 1849
12
William Sibley Putney
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.1.5.3]
b. 24 Mar 1849 d. 16 Jan 1933
12
Clara A Putney
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.1.5.4]
b. 28 Sep 1850
12
Mary Ann Putney
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.1.5.5]
b. 25 Dec 1852 d. 13 May 1881 [
=>
]
12
Josephine E Putney
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.1.5.6]
b. 16 Dec 1854 d. 26 Dec 1857
12
Orrin F Putney
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.1.5.7]
b. 20 Dec 1856 d. 20 Mar 1881
12
Luther C Putney
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.1.5.8]
b. 26 Jul 1859 d. 1920 [
=>
]
12
Fred Willard Putney
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.1.5.9]
b. 21 Jan 1866 d. 26 Dec 1930 [
=>
]
11
Almira S Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.1.6]
10
Mary Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.2]
b. 5 Dec 1780
+
Amariah Scarboro
10
Anne Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.3]
b. 15 Jan 1782
10
Cyrus Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.4]
b. 6 Jan 1784
Eliza Ann Humphries
b. 9 Sep 1809 d. 4 Oct 1884
11
Artemas Origin Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.4.1]
b. 9 Mar 1829
Eloise Soria
12
Robert A Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.4.1.1]
b. 25 Nov 1855 d. 18 Jul 1902
12
Artemise Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.4.1.2]
b. 1861
12
Eugene Walter Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.4.1.3]
b. 25 Mar 1865 d. 23 Apr 1945 [
=>
]
12
Cyrus Artemas Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.4.1.4]
b. 25 Aug 1866 d. 25 Aug 1949 [
=>
]
12
Hattie S Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.4.1.5]
b. 1870
12
Annie Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.4.1.6]
b. 1872
12
William Soria Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.4.1.7]
b. 12 Sep 1874 d. 12 Feb 1968
11
Salome Jane Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.4.2]
b. 19 Dec 1829 d. 12 Apr 1835
11
Artemesia Ann Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.4.3]
b. 31 Jul 1830 d. 1 Sep 1903
Robert Brown Searing
b. 15 May 1829 d. 2 May 1890
12
Robert Brian Searing
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.4.3.1]
b. 1859 d. 1878
12
Harry Pond Searing
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.4.3.2]
b. 1863 d. 20 Dec 1873
12
Cyrus Sibley Searing
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.4.3.3]
12
Florence Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.4.3.4]
12
Theodore Searing
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.4.3.5]
11
Willard Franklin Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.4.4]
b. 18 Apr 1835
11
Cyrus Blue Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.4.5]
b. 18 Apr 1837
11
Helena Jane Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.4.6]
b. 27 May 1839
11
Henrietta Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.4.7]
b. 1842 d. 6 Feb 1892
11
Walter Howard Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.4.8]
11
Augustus Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.4.9]
10
Artemas Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.5]
b. 21 Apr 1786
10
Salome Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.6]
b. 13 Apr 1788 d. Aft 1880
Elijah Jewett
b. 8 Feb 1782 d. 1879
11
John F Jewett
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.6.1]
b. 1817
+
Elizabeth How
b. Abt 1819
11
Origin Sibley Jewett
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.6.2]
b. 20 Apr 1820 d. 19 Sep 1863
Clara Lee James
b. 25 Oct 1832 d. 1912
12
Origin Sibley Jewett
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.6.2.1]
b. 1860 d. 1908 [
=>
]
11
Mary Elizabeth Jewett
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.6.3]
b. Abt 1821 d. 1901
Armistead M Elgin
b. 1819
12
Isabella Elgin
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.6.3.1]
b. 20 May 1857 d. 30 May 1924 [
=>
]
12
Willie A Elgin
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.6.3.2]
b. 18 Jan 1860 d. 12 Apr 1875
12
Clara J Elgin
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.6.3.3]
b. Abt 1863 d. 25 Apr 1959
12
Elizabeth May Elgin
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.6.3.4]
b. 1867 d. 24 Jan 1936
10
Benijamin Franklin Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.7]
b. 19 Jul 1790
10
Origen Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.8]
b. 1792 d. 1870
Elizabeth Barlow
b. 8 May 1815 d. 2 Jul 1875
11
Josephine Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.8.1]
b. 2 Jul 1835 d. 3 Mar 1873
George W Barnaby
d. 1859
12
Bessie Barnaby
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.8.1.1]
b. 14 Jan 1857
12
George Adam Barnaby
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.8.1.2]
b. 14 Jan 1857 d. 1897
William Motley Stevens
d. 1870
12
Lloyd Motley Stevens
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.8.1.3]
b. 13 Jan 1869 d. 13 Jun 1955
11
Salome Elizabeth Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.8.2]
b. 19 Aug 1837 d. 1 Nov 1893
Nathaniel Ragan King
b. 18 Jun 1831 d. 19 Nov 1863
12
Marietta King
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.8.2.1]
b. 8 Sep 1858 [
=>
]
12
Sibley Paul King
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.8.2.2]
b. 5 Jun 1860
12
Idyl King
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.8.2.3]
b. 23 Feb 1862 [
=>
]
12
Nathalie Ragan King
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.8.2.4]
b. 6 May 1863 [
=>
]
11
Origen Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.8.3]
b. 6 Feb 1840
Harriet A Brainerd
b. 1 Feb 1845
12
James Brainard Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.8.3.1]
b. 15 May 1869
12
Origen Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.8.3.2]
b. 30 Jun 1872
12
Orlean Emma Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.8.3.3]
b. 30 Jun 1872 d. 27 Oct 1872
12
Will Owen Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.8.3.4]
b. 1 May 1880 d. 13 Aug 1880
11
Laura Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.8.4]
b. 1842
William G McNeill
12
Mary Elizabeth McNeill
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.8.4.1]
b. 8 Mar 1865 [
=>
]
12
William Stoddard McNeill
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.8.4.2]
b. 6 Dec 1866 d. 14 Apr 1868
12
Laurence Harvey McNeill
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.8.4.3]
b. 10 Aug 1869
12
Fanny Ethel McNeill
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.8.4.4]
b. 21 May 1871
12
Daniel McNeill
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.8.4.5]
b. 22 Sep 1872
12
Lila Douglas McNeill
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.8.4.6]
b. 10 Apr 1877 d. 1954
11
Franklin Edward Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.8.5]
b. 1844
Ida K Sterne
12
Helen May Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.8.5.1]
b. 1879 d. 1880
12
Frank Eillott Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.8.5.2]
b. 1881 d. 1943
12
Ida Valerie Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.8.5.3]
b. 1883 d. 1979
12
Julian Dannis Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.8.5.4]
b. 1885 d. 1964
12
Rowland Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.8.5.5]
b. 1890 d. 1901
11
Helen Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.8.6]
b. 15 Dec 1846 d. 1940
Audubon Gullette
12
Laura Helen Gullette
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.8.6.1]
b. 30 Oct 1867 [
=>
]
12
Elizabeth Gullette
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.8.6.2]
b. 1869
12
Eugenia Gullette
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.8.6.3]
b. 9 Mar 1874
11
Charles Sweet Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.8.7]
b. 25 Jan 1849
Edna G D'Olive
b. 1872
12
Edna Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.8.7.1]
b. Dec 1890 d. 1987
11
Eugene Wilson Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.8.8]
b. 16 Sep 1851 d. 4 Mar 1911
Minnie M Sterne
12
Edward Austin Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.8.8.1]
d. 1960
12
Elizabeth Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.8.8.2]
d. 1896
12
Laurence Sterne Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.8.8.3]
d. 1901
11
Guy Clarence Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.8.9]
b. 1855
Susie Witherspoon Shipman
b. 29 Apr 1858 d. 27 Mar 1934
12
Guy Clarence Shipley, Jr
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.8.9.1]
b. 28 Jan 1883 d. 21 Feb 1912
11
Julia Eve Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.8.10]
b. 16 Jan 1856
Edward L Barnes
b. 23 Jan 1850
12
Anderson Barnes
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.8.10.1]
b. 28 Oct 1877
12
Origen Sibley Barnes
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.8.10.2]
b. 2 Sep 1879 d. 1884
12
Edward L Barnes
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.8.10.3]
12
Pendleton Barnes
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.8.10.4]
12
Sager Barnes
[1.2.12.4.1.5.4.4.2.8.10.5]
9
Joshua Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.3]
b. 16 Nov 1755 d. 29 Sep 1774
9
Stephen Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.4]
b. 19 May 1757 d. 2 Jun 1759
9
Stephen Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.5]
b. 10 Nov 1759 d. 21 Apr 1829
9
Ebenezer Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.6]
b. 7 Apr 1761 d. 10 Sep 1839
Lydia Beach
b. 15 May 1766 d. 6 Mar 1834
10
John Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.6.1]
b. 3 Jul 1791
Nancy Kellog
b. 12 Mar 1809 d. 13 Jun 1885
11
Huldah Ann Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.6.1.1]
b. 13 Dec 1839 d. 30 Aug 1874
Carlos C Martin
b. 28 Dec 1819 d. 23 Oct 1894
12
Carlos Sibley Martin
[1.2.12.4.1.5.4.4.6.1.1.1]
b. 22 Jul 1866 d. 19 Jun 1952 [
=>
]
12
George Chapman Martin
[1.2.12.4.1.5.4.4.6.1.1.2]
b. 17 May 1868 d. 23 Jun 1921
11
Ebenezer Kellogg Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.6.1.2]
b. 21 Sep 1841 d. 29 Sep 1895
+
Ellen Welty
b. 21 Jul 1848 d. 8 Sep 1931
11
George Whitney Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.6.1.3]
b. 17 Jan 1843 d. 7 Jul 1911
Mary L Woodward
b. 21 Sep 1845 d. 1 Jan 1876
12
George Woodward Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.6.1.3.1]
b. 2 Apr 1869 d. 3 Nov 1941 [
=>
]
12
John Whitney Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.6.1.3.2]
b. 19 Jan 1875
Reteena Jasmine Sanders
b. 26 Apr 1850 d. 2 Jun 1929
12
Anna May Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.6.1.3.3]
b. 28 Oct 1879 d. 4 Sep 1962 [
=>
]
12
Elizabeth Kellogg Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.6.1.3.4]
b. 29 Aug 1884 d. 6 Sep 1943
12
John Whitney Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.6.1.3.5]
b. 17 Mar 1886 d. 29 Jul 1976
11
John Nelson Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.6.1.4]
b. 10 Nov 1844 d. 4 Jan 1880
11
Benjamin Franklin Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.6.1.5]
b. 5 Aug 1846 d. 1907
Lucia Marion Hill
b. 27 Dec 1848
12
Delia M Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.6.1.5.1]
b. 1874 d. 1876
12
William H Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.6.1.5.2]
b. 1877 d. 1888
12
Arthur K Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.6.1.5.3]
b. 1882 d. 1888
12
Hiram W Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.6.1.5.4]
b. 1884 d. 1886
12
George H Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.6.1.5.5]
b. 1892 d. 1893
11
Hiram Beach Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.6.1.6]
b. 4 Mar 1849 d. 20 Sep 1876
+
Mary Ann Wheeler
b. 13 Apr 1851 d. 25 Jan 1926
10
Timothy Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.6.2]
b. 4 Feb 1803 d. 24 Sep 1880
9
Anna Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.7]
b. 15 Dec 1762 d. 17 Sep 1792
Samuel Hoyt
b. 24 Jan 1739 d. 22 Nov 1821
10
Lydia Hoyt
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.1]
b. 9 Apr 1779 d. Aft 1850
Jonathan Bean
b. 26 Feb 1776 d. 9 Nov 1844
11
Sopia Bean
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.1.1]
b. 16 Jun 1799
11
Fanny Bean
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.1.2]
b. 20 Jan 1801
11
Otis Bean
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.1.3]
b. 26 Dec 1802
11
Asa Bean
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.1.4]
b. 13 Mar 1805 d. 18 Apr 1856
Jane D Stone
b. 20 Jan 1820 d. 30 Jul 1896
12
Leenze Bean
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.1.4.1]
b. 4 Sep 1840 d. 1 Mar 1841
12
Julia Ann Judson Bean
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.1.4.2]
b. 15 Feb 1842 d. 7 Jul 1927
12
Adeniran Judson Bean
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.1.4.3]
b. Abt 1843 d. 12 Jun 1888
12
Harriet Newell Bean
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.1.4.4]
b. 21 Jun 1847 d. 25 Dec 1928
12
William Gustin Bean
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.1.4.5]
b. 8 Jan 1850 d. 5 Apr 1850
12
Fanny Jeanette Bean
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.1.4.6]
b. 28 May 1852 [
=>
]
12
Margaret Jane Bean
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.1.4.7]
b. 6 Mar 1855
11
Synthia Bean
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.1.5]
b. 26 Dec 1807 d. 15 Oct 1816
11
Eliza Bean
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.1.6]
b. 26 Dec 1807 d. 15 Oct 1816
11
Rueben C Bean
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.1.7]
b. 2 Apr 1809
+
Elizabeth
11
Ann Bean
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.1.8]
b. 22 May 1811
11
Mary Bean
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.1.9]
b. 2 May 1813
11
Martha Bean
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.1.10]
b. 15 Dec 1815 d. 6 Jan 1818
10
Anna Hoyt
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.2]
b. 26 Sep 1781 d. 16 Sep 1865
Paulus Tenney
b. 24 Sep 1781 d. 29 Sep 1841
11
Maria Tenney
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.2.1]
b. 4 Jun 1805 d. 1 May 1812
11
Franklin Tenney
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.2.2]
b. 5 Nov 1806 d. 15 Nov 1878
11
Nancy S Tenney
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.2.3]
b. 28 Oct 1808 d. 1885
James French
b. 1 Apr 1815
12
Rebecca Ann French
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.2.3.1]
b. 26 Jan 1838
12
James Paulus French
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.2.3.2]
b. 4 Apr 1840
12
Mary Elizabeth French
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.2.3.3]
b. 24 Aug 1842
12
Jonathan John French
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.2.3.4]
b. 31 Jan 1845
12
Samuel S French
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.2.3.5]
b. 21 Dec 1847 d. 12 Jan 1851
12
William Harris French
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.2.3.6]
b. 29 Oct 1850 d. 11 Jan 1851
12
Solon Tenney French
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.2.3.7]
b. 15 Oct 1851 d. 27 Dec 1908
11
Sylvainus Tenny
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.2.4]
b. 6 Oct 1810 d. 12 Oct 1888
Mary Jane Bay
b. 21 Mar 1818
12
Paul Hugh Tenney
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.2.4.1]
b. 1 May 1839 d. 29 Sep 1868 [
=>
]
12
Arkalon Tenney
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.2.4.2]
b. 26 Jun 1841 [
=>
]
12
Curtis Monroe Tenney
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.2.4.3]
b. 2 Aug 1847 d. 10 Dec 1850
12
William Lafayette Tenney
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.2.4.4]
b. 30 Apr 1851 [
=>
]
12
Zilpha Tenney
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.2.4.5]
b. 1853 d. 1856
12
Mary Mariah Tenney
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.2.4.6]
b. 4 Sep 1844 d. 15 Jan 1933 [
=>
]
12
James F Tenney
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.2.4.7]
b. 1856 [
=>
]
10
William Hoyt
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.3]
b. 24 Jul 1783 d. 19 Feb 1813
Polly French
b. Abt 1785
11
Freeman Hoyt
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.3.1]
b. 1805
11
Mary French Hoyt
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.3.2]
b. Abt 1809
+
Cheney
b. Abt 1845
11
Sewell Hoyt
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.3.3]
b. Abt 1811
11
William Hoyt
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.3.4]
b. Abt 1813
11
French Hoyt
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.3.5]
b. Abt 1815
10
Sarah Hoyt
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.4]
b. 13 Feb 1786 d. 14 Nov 1862
John Hoyt
b. 2 Dec 1787
11
Sophronia Hoyt
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.4.1]
b. 21 Dec 1810 d. 12 Feb 1889
Joel Blackman
b. 21 Dec 1810 d. 22 Jun 1901
12
True Worthy Blackman
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.4.1.1]
b. 27 Nov 1836 d. 16 Jan 1925 [
=>
]
12
John Monroe Blackman
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.4.1.2]
b. 1852 d. 7 Jun 1871
12
Virgil W Blackman
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.4.1.3]
b. 3 Jul 1857 d. 1921 [
=>
]
11
William Hoyt
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.4.2]
b. 12 Oct 1813
+
Mrs Hoyt
11
Samuel True Hoyt
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.4.3]
b. Abt 1814
11
True Worthy Hoyt
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.4.4]
b. 31 Aug 1815 d. 1900
Phebe Ann Jameson
b. 1820
12
Phoebe Sophronia Hoyt
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.4.4.1]
b. 12 May 1847 d. 4 Aug 1849
12
Sarah Elizabeth Hoyt
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.4.4.2]
b. 16 Aug 1850 d. 22 Jan 1855
12
True Worthy Hoit
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.4.4.3]
b. 15 May 1853
12
Elisabeth Jamison Hoit
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.4.4.4]
b. 16 Jun 1856
12
Homer A Hoit
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.4.4.5]
b. 17 Dec 1858 d. 28 Feb 1923
12
Fanny Story Hoyt
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.4.4.6]
b. 19 Oct 1861
11
Albert Lewis Hoyt
[1.2.12.4.1.5.4.4.7.4.5]
b. 23 Dec 1822 d. 10 Aug 1843
9
Asa Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.8]
b. 29 Mar 1764 d. 25 Feb 1829
Irene Carpenter
b. 28 Jan 1766 d. 5 Oct 1846
10
Derick Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.8.1]
b. 22 May 1788 d. Abt 1846
Rachael Roberts
b. 1800 d. Aft 1860
11
Caroline Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.8.1.1]
b. 1833 d. Aft 1860
W L Evans
b. 1827 d. Aft 1860
12
Anna B Evans
[1.2.12.4.1.5.4.4.8.1.1.1]
b. 1852 d. Aft 1860
10
Sophia Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.8.2]
b. 5 Oct 1790 d. 4 Feb 1841
Oren Hall
b. 1789 d. Dec 1820
11
Sophia Edna Hall
[1.2.12.4.1.5.4.4.8.2.1]
b. 1 Apr 1809 d. 1870
Edwin Thomson
b. 1808 d. Abt 1857
12
Mortimer Neal Thomson
[1.2.12.4.1.5.4.4.8.2.1.1]
b. 2 Sep 1831 d. 25 Jun 1875 [
=>
]
12
Clifford Thomson
[1.2.12.4.1.5.4.4.8.2.1.2]
b. 15 Apr 1834 d. 29 Sep 1912 [
=>
]
11
Edwin Oscar Hall
[1.2.12.4.1.5.4.4.8.2.2]
b. 21 Oct 1810 d. 19 Sep 1883
Sarah Lyon Williams
b. 27 Oct 1812 d. 15 Aug 1876
12
Sophia Elizabeth Hall
[1.2.12.4.1.5.4.4.8.2.2.1]
b. 4 Jul 1836 d. 26 May 1863 [
=>
]
12
Caroline Alice Hall
[1.2.12.4.1.5.4.4.8.2.2.2]
b. 5 Nov 1839 d. 29 Jan 1868
12
William Wisner Hall
[1.2.12.4.1.5.4.4.8.2.2.3]
b. 1 Jun 1841 d. 23 May 1910 [
=>
]
12
Cornelia Hall
[1.2.12.4.1.5.4.4.8.2.2.4]
b. 25 Aug 1842 d. 27 Apr 1911 [
=>
]
+
Mary Lyon Dame
b. 6 Oct 1848 d. 16 Mar 1908
11
Asa Sibley Hall
[1.2.12.4.1.5.4.4.8.2.3]
b. 23 Apr 1818
Joseph Willard Seymour
b. 29 Mar 1781 d. 25 Jan 1867
11
Oren T Seymour
[1.2.12.4.1.5.4.4.8.2.4]
b. 1824
11
Mary E. Seymour
[1.2.12.4.1.5.4.4.8.2.5]
b. Abt 1825 d. Aft 1850
11
Theodore S. Seymour
[1.2.12.4.1.5.4.4.8.2.6]
b. 1 Jul 1828 d. 1902
10
Lucy Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.8.3]
b. 21 Jul 1792 d. 18 Jul 1795
10
Levi Waite Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.8.4]
b. 4 Mar 1801 d. 13 Aug 1844
Nancy Ann Remington
b. 18 Sep 1801 d. 9 Jan 1870
11
Augustus Furburt Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.8.4.1]
b. 15 Jul 1827
Mary Williamsen Ogden
b. 20 May 1838 d. 15 Jan 1890
12
Herman Clark Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.8.4.1.1]
b. 22 Nov 1860
11
Amanda Maria Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.8.4.2]
b. 25 Oct 1829 d. 31 Mar 1861
John Francis Hoyt
b. 18 Oct 1816
12
Harriet M Hoyt
[1.2.12.4.1.5.4.4.8.4.2.1]
b. 19 Oct 1849
11
William Wisner Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.8.4.3]
b. 4 Feb 1831 d. 30 Jun 1870
+
Helen Jane Wilcox
b. 31 Aug 1831
11
Harriet Remington Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.8.4.4]
b. 12 Jul 1833 d. Aug 1844
11
George Ainsworth Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.8.4.5]
b. 13 Jun 1834 d. 29 Dec 1856
11
Levi Edwin Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.8.4.6]
b. 8 Sep 1839 d. 29 Oct 1900
Sarah Ella Martling
b. Oct 1852 d. 28 Dec 1932
12
Lucy M Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.8.4.6.1]
b. 1876 d. 1888
12
William W Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.8.4.6.2]
b. Dec 1877 [
=>
]
12
George Edwin Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.8.4.6.3]
b. 24 Jun 1881
10
Mary Ann Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.8.5]
b. 18 Dec 1804 d. 18 Oct 1870
Edwin Scrantom
b. 9 May 1803 d. 3 Oct 1880
11
Stella Benton Scrantom
[1.2.12.4.1.5.4.4.8.5.1]
b. 12 Jan 1827
+
Galusha Phillips
b. 27 Apr 1820 d. 1880
11
Adrian George Scrantom
[1.2.12.4.1.5.4.4.8.5.2]
b. 26 Oct 1828 d. 1880
+
Mary Sheldon
b. Abt 1832
+
Charlotta
d. 1880
+
Helen Jane Wilcox
b. 31 Aug 1831 d. Abt 1900
11
Cora Irene Scrantom
[1.2.12.4.1.5.4.4.8.5.3]
b. 28 Jun 1830 d. 31 Dec 1858
John E Sabine
b. Abt 1826 d. 7 Jul 1854
12
Cora Lovisa Sabine
[1.2.12.4.1.5.4.4.8.5.3.1]
b. 30 Jan 1850
12
Mary Irene Sabine
[1.2.12.4.1.5.4.4.8.5.3.2]
b. 8 Jan 1853 [
=>
]
12
Sibly Phillips Sabine
[1.2.12.4.1.5.4.4.8.5.3.3]
b. 23 Dec 1854
George Williams
b. 24 Nov 1831 d. 10 Feb 1895
12
Child Williams
[1.2.12.4.1.5.4.4.8.5.3.4]
b. 31 Dec 1858 d. 31 Dec 1858
11
Edwina Jane Scrantom
[1.2.12.4.1.5.4.4.8.5.4]
b. 24 Sep 1832 d. Abt 1839
11
Hamlet Edwin Scrantom
[1.2.12.4.1.5.4.4.8.5.5]
b. Abt 1833 d. Abt 1833
11
Beulah Mary Scrantom
[1.2.12.4.1.5.4.4.8.5.6]
b. 15 Jan 1835 d. 1 Jan 1900
Isaac H Weaver
b. Abt 1831 d. Bef 1867
12
Edwin James Weaver
[1.2.12.4.1.5.4.4.8.5.6.1]
b. 1857 d. 12 Aug 1874
Ensley Mills Smith
b. 8 Aug 1828 d. 7 May 1886
12
Emmalita A Smith
[1.2.12.4.1.5.4.4.8.5.6.2]
b. 12 Apr 1868 d. 29 Sep 1879
12
Mary Elizabeth Smith
[1.2.12.4.1.5.4.4.8.5.6.3]
b. 6 Jul 1870 d. 13 Oct 1879
12
Ensley Boyd Smith
[1.2.12.4.1.5.4.4.8.5.6.4]
b. 10 Jan 1876 d. 7 Aug 1956
11
Edwin Levi Scrantom
[1.2.12.4.1.5.4.4.8.5.7]
b. Abt 1837 d. Abt 1837
11
Clifford Sibley Scrantom
[1.2.12.4.1.5.4.4.8.5.8]
b. Abt 1841 d. Abt 1844
11
Melford Clark Scrantom
[1.2.12.4.1.5.4.4.8.5.9]
b. 4 Nov 1844 d. Abt 1845
11
Bertha Sibley Scranton
[1.2.12.4.1.5.4.4.8.5.10]
b. 29 Nov 1848
10
George Ainsworth Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.8.6]
b. 9 Apr 1809 d. 1 Jun 1836
10
Daughter Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.8.7]
c. 1 Oct 1809 d. 1809
9
Jonathan Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.9]
b. 8 May 1766 d. 20 Feb 1823
Mary Davis
b. 24 Feb 1768 d. 23 Jun 1840
10
Davis Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.9.1]
b. 29 Nov 1788 d. 21 Nov 1828
Cynta Fisher
b. Abt 1797 d. 6 Jul 1874
11
Nelson Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.9.1.1]
b. 4 Mar 1820 d. 10 Mar 1850
11
Franklin Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.9.1.2]
b. 1 Oct 1821 d. 1878
Julia Badger Leavitt
b. 29 Jul 1826 d. 28 Jan 1864
12
Mary Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.9.1.2.1]
b. 1847
12
Frederick M Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.9.1.2.2]
b. Jun 1849 d. 2 Oct 1912
12
Davis Origin Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.9.1.2.3]
b. 28 Jun 1853 d. 22 May 1913
12
George F Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.9.1.2.4]
b. Sep 1853
12
Walter Frank Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.9.1.2.5]
b. Sep 1857 d. 4 Jun 1911 [
=>
]
12
John L Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.9.1.2.6]
b. 1859
Ellen W Floyd
b. 1836 d. 1 Jul 1878
12
Ernia M Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.9.1.2.7]
b. Jun 1878 d. 12 Jul 1878
12
Ena L Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.9.1.2.8]
b. Jun 1878 d. 30 Jun 1878
11
Laura Messenger Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.9.1.3]
b. 6 Dec 1822 d. 13 Jan 1861
11
Mary Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.9.1.4]
b. 15 Apr 1825 d. 21 Aug 1826
11
Martha Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.9.1.5]
b. 18 Jun 1826 d. Sep 1826
11
Mary Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.9.1.6]
b. 7 Aug 1827 d. 16 Oct 1840
11
Caroline F Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.9.1.7]
b. 14 Dec 1828 d. 7 Apr 1853
+
Cyrus Harris
10
Mary Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.9.2]
b. 13 Apr 1792 d. 9 Nov 1844
Augustine White
b. 19 Jan 1777
11
Mary Ann White
[1.2.12.4.1.5.4.4.9.2.1]
b. 19 Apr 1812 d. 12 May 1823
11
Eliza Malvina White
[1.2.12.4.1.5.4.4.9.2.2]
b. 30 Nov 1814 d. 7 Apr 1858
+
Henry W Nichols
11
Cynthia Sibley White
[1.2.12.4.1.5.4.4.9.2.3]
b. 8 May 1818
11
Augusta Holven White
[1.2.12.4.1.5.4.4.9.2.4]
b. 28 Jan 1821
+
Daniel Scott
11
Lucy Violy White
[1.2.12.4.1.5.4.4.9.2.5]
b. 20 Oct 1824 d. Jul 1845
11
John S White
[1.2.12.4.1.5.4.4.9.2.6]
b. 2 Jul 1827
+
Emilie Jouret
11
Davis J White
[1.2.12.4.1.5.4.4.9.2.7]
b. 27 Jan 1833
10
Jonathan W Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.9.3]
b. 13 Aug 1800 d. 26 Sep 1829
Brooksey Case
b. 30 Sep 1804 d. 15 Mar 1829
11
Albert C Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.9.3.1]
b. 3 Jun 1828 d. Feb 1852
9
Benjamin Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.10]
b. 29 Apr 1768 d. 2 Oct 1829
Zilpah Davis
b. 13 Apr 1771 d. 16 May 1824
10
Samuel Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.10.1]
b. 30 Nov 1792 d. 4 Mar 1858
Lucinda Holbrock
b. 19 Mar 1806 d. 2 Mar 1830
11
Giles H Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.10.1.1]
b. 26 May 1825 d. 10 Jun 1825
11
Morella Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.10.1.2]
b. 19 Jun 1827 d. 31 Jul 1849
11
Lucinda Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.10.1.3]
b. 12 Jul 1829 d. 4 Sep 1854
Almira Dixon
b. 3 Apr 1807
11
Elizabeth H Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.10.1.4]
b. 20 Nov 1833
+
Joseph Fisk
11
Mary Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.10.1.5]
b. 16 Jan 1838 d. 17 Aug 1839
11
Helen Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.10.1.6]
b. 23 Sep 1842 d. 3 Feb 1844
11
George H Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.10.1.7]
b. 25 Aug 1845
+
Theodocia Townsend
10
Patty Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.10.2]
b. 6 Feb 1799 d. 12 Jul 1805
10
Nancy Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.10.3]
b. 7 Feb 1806 d. 14 Feb 1806
10
Hiram Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.10.4]
b. 6 Feb 1807 d. 12 Jul 1888
Elizabeth Maria Tinker
b. 11 Aug 1815 d. 11 Jul 1903
11
Zilpha Louisa Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.10.4.1]
b. 7 Dec 1833 d. 16 Jun 1868
Hobart Ford Atkinson
b. 5 Oct 1825 d. 14 Aug 1908
12
Marie Louise Atkinson
[1.2.12.4.1.5.4.4.10.4.1.1]
b. 24 Feb 1864 d. 29 Oct 1940
12
Elizabeth Storer Atkinson
[1.2.12.4.1.5.4.4.10.4.1.2]
b. Abt 1866 bur. 16 Feb 1945
11
Giles Benjamin Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.10.4.2]
b. 8 Apr 1841 d. 14 Mar 1843
11
Hiram Watson Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.10.4.3]
b. 2 Mar 1845 d. 28 Jun 1932
Margaret Durbin Harper
b. 14 Feb 1852 d. 28 May 1939
12
Margaret Harper Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.10.4.3.1]
b. 14 Dec 1873 d. 30 Nov 1874
12
Hiram Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.10.4.3.2]
b. 24 Jul 1875 d. 12 Apr 1886
12
John Durbin Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.10.4.3.3]
b. 3 Nov 1883 d. 18 Sep 1888
12
Fletcher Harper Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.10.4.3.4]
b. 5 Apr 1885 d. 24 Apr 1959 [
=>
]
12
Margaret Urling Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.10.4.3.5]
b. 17 Jan 1893 d. 3 Apr 1951
11
Emily Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.10.4.4]
b. 10 May 1855 d. 8 Feb 1945
Isaac Seymour Averill
b. 21 Jun 1850 d. 25 Oct 1909
12
Elizabeth Louise Averell
[1.2.12.4.1.5.4.4.10.4.4.1]
b. 25 Jan 1877 d. 2 Apr 1886
12
James G Averell
[1.2.12.4.1.5.4.4.10.4.4.2]
b. 23 Dec 1877 d. 30 Nov 1904
James Sibley Watson
b. 11 Mar 1860 d. 1951
12
James Sibley "Sibley" Watson, Jr
[1.2.12.4.1.5.4.4.10.4.4.3]
b. 10 Aug 1894 d. 31 Mar 1982 [
=>
]
9
Soloman Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.11]
b. 17 Nov 1769
Sally Stockwell
b. 21 Jan 1774
10
Stephen Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.11.1]
b. 12 Dec 1792
10
Nancy Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.11.2]
b. 19 Jan 1797
+
Nathan Muzzy
b. 24 Dec 1792 d. 23 Jun 1858
10
Heister Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.11.3]
b. 19 Jun 1799
10
Lewis Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.11.4]
b. 8 Jul 1801
10
Stephen Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.11.5]
b. 26 Jul 1805
Charlotte Reed Peirce
b. 7 Jul 1811 d. 22 Aug 1882
11
John Reed Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.11.5.1]
b. 18 Apr 1838
11
George H Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.11.5.2]
b. 17 Aug 1841
+
Emma J Gould
b. 8 Jul 1850
11
Martha P Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.11.5.3]
b. 16 Nov 1843
11
Mary Charlotte Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.11.5.4]
b. 18 May 1847
Albert Marritt Phillips
b. 9 Oct 1843
12
Clara Willis Phillips
[1.2.12.4.1.5.4.4.11.5.4.1]
b. 13 May 1884
11
Clara Sophronia Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.11.5.5]
b. 8 Nov 1849
Otis Sumner Pond
b. 3 Nov 1846
12
Arthur N Pond
[1.2.12.4.1.5.4.4.11.5.5.1]
b. 1 Mar 1873
12
Herbert Carroll Pond
[1.2.12.4.1.5.4.4.11.5.5.2]
b. 26 May 1877 d. 7 Dec 1930 [
=>
]
10
Solomon Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.11.6]
b. 14 Jun 1808
10
John Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.11.7]
b. 20 Feb 1818 d. 17 Aug 1824
9
Polly Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.12]
b. 4 Dec 1771
Abner C Cummings
b. 9 Oct 1770 d. 1800
10
Nancy Cummings
[1.2.12.4.1.5.4.4.12.1]
b. 5 Nov 1795
John Putnam
b. Abt 1792
11
Dulcina Putnam
[1.2.12.4.1.5.4.4.12.1.1]
b. 12 Dec 1813 d. 20 Jul 1816
11
Harriet Putnam
[1.2.12.4.1.5.4.4.12.1.2]
b. 20 Mar 1815 d. 20 Jul 1816
11
Jane Putnam
[1.2.12.4.1.5.4.4.12.1.3]
b. 1 Nov 1816
Walters Putnam
b. 16 Mar 1817
12
Sarah Jane Putnam
[1.2.12.4.1.5.4.4.12.1.3.1]
b. 1 Nov 1841
12
Nancy L Putnam
[1.2.12.4.1.5.4.4.12.1.3.2]
b. 15 Aug 1845
12
Marble Putnam
[1.2.12.4.1.5.4.4.12.1.3.3]
b. 19 Aug 1847 [
=>
]
12
Martha Waters Putnam
[1.2.12.4.1.5.4.4.12.1.3.4]
b. 3 Nov 1849 d. 8 Feb 1856
12
Henry Waters Putnam
[1.2.12.4.1.5.4.4.12.1.3.5]
b. 1 Oct 1855
11
John Perry Putnam
[1.2.12.4.1.5.4.4.12.1.4]
b. 27 Mar 1818
11
Ira Putnam
[1.2.12.4.1.5.4.4.12.1.5]
b. 15 Nov 1819 d. 12 May 1821
11
Ephraim Laughton Putnam
[1.2.12.4.1.5.4.4.12.1.6]
b. 30 Apr 1821 d. 3 Dec 1822
10
Clarissa Cummings
[1.2.12.4.1.5.4.4.12.2]
b. 18 Apr 1796 d. 1838
Creenfield Pote Merrill
b. 26 Aug 1794 d. 27 Mar 1876
11
Edward Pote Merrill
[1.2.12.4.1.5.4.4.12.2.1]
b. 22 Oct 1820 d. 1870
+
Olive B Lincoln
b. 1823
11
Elizabeth C Merrill
[1.2.12.4.1.5.4.4.12.2.2]
b. 26 Feb 1822 d. 16 Dec 1839
11
Greenfield Merrill
[1.2.12.4.1.5.4.4.12.2.3]
b. 14 Dec 1825
11
Samuel Merrill
[1.2.12.4.1.5.4.4.12.2.4]
b. 28 Oct 1832 d. 1912
11
Creenfield Merrill
[1.2.12.4.1.5.4.4.12.2.5]
b. 14 Dec 1834
11
Daniel Cummings Merrill
[1.2.12.4.1.5.4.4.12.2.6]
b. 20 Mar 1837 d. 1925
+
Mary A Noyes
b. 23 May 1841 d. 28 Feb 1893
9
Artamus Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.13]
b. 9 Jul 1773 d. 10 Aug 1777
9
Nahum Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.14]
b. 11 Sep 1775 d. 12 Sep 1796
9
Sally Sibley
[1.2.12.4.1.5.4.4.15]
b. 6 Jun 1779 d. 21 Mar 1833
Amasa Cummings
b. 17 Jan 1778 d. 22 Mar 1836
10
Abner Cummings
[1.2.12.4.1.5.4.4.15.1]
b. 1 Jan 1808
10
Sarah Ann Cummings
[1.2.12.4.1.5.4.4.15.2]
b. 22 Oct 1812
10
Nahum Sibley Cummings
[1.2.12.4.1.5.4.4.15.3]
b. 7 Jan 1816
+
Hannah Amidon
b. Abt 1730 d. 5 Jun 1822
7
David Gould
[1.2.12.4.1.5.5]
b. 21 Apr 1694 d. 21 Apr 1694
7
Ebenezer Gould
[1.2.12.4.1.5.6]
b. 17 Oct 1696
7
Hannah Gould
[1.2.12.4.1.5.7]
b. 6 Nov 1698 d. Abt 1758
6
Joshua Rea
[1.2.12.4.1.6]
b. 6 Aug 1664 d. 1710
Elizabeth Leach
b. Abt 1666 d. Aft 1698
7
Hanna Rea
[1.2.12.4.1.6.1]
b. Abt 1686 d. 2 Nov 1786
7
Sarah Rea
[1.2.12.4.1.6.2]
b. 28 Apr 1686 d. 9 Jul 1709
7
Elizabeth Rea
[1.2.12.4.1.6.3]
b. 13 Aug 1687 d. 14 Dec 1711
7
Kesia Rea
[1.2.12.4.1.6.4]
b. 1 Sep 1689 d. 14 Jun 1724
7
Joshua Rea
[1.2.12.4.1.6.5]
b. 16 Oct 1691 d. 13 Jan 1770
7
Lydia Rea
[1.2.12.4.1.6.6]
b. Mar 1693 d. Aft 1694
6
John Rea
[1.2.12.4.1.7]
b. 23 May 1666 d. 20 Mar 1731
Ruth Putnam
b. Aug 1673
7
John Rhea
[1.2.12.4.1.7.1]
b. 21 Jun 1702 d. 1750
6
Hannah Rea
[1.2.12.4.1.8]
b. 1 Aug 1668
5
Phebe Waters
[1.2.12.4.2]
b. Abt 1638 d. 16 Apr 1672
Thomas West
c. 16 Oct 1629 d. 27 Dec 1720
6
Joseph West
[1.2.12.4.2.1]
b. 13 Jul 1663 d. 26 Nov 1739
6
Benjamin West
[1.2.12.4.2.2]
b. 1 Oct 1665 d. 11 Dec 1733
6
John West
[1.2.12.4.2.3]
b. 1666 d. 1741
6
Samuel West
[1.2.12.4.2.4]
b. 23 Mar 1659 d. 1695
Rhoda Meacham
b. 1661 d. Oct 1695
7
Samuel West
[1.2.12.4.2.4.1]
b. Abt 1685
5
James Waters
[1.2.12.4.3]
b. Abt 1638 d. 11 Sep 1704
Mary Stallworthy
b. 1642 d. 22 May 1695
6
Mary Waters
[1.2.12.4.3.1]
b. Abt 7 Feb 1670
6
Elizabeth Waters
[1.2.12.4.3.2]
b. 23 May 1672
6
Abigail Waters
[1.2.12.4.3.3]
b. 21 Apr 1677
6
Samuel Waters
[1.2.12.4.3.4]
b. 22 May 1679 d. 12 Feb 1742
6
Daniel Waters
[1.2.12.4.3.5]
b. 29 Mar 1682 d. 19 Dec 1704
6
Stallworthie Waters
[1.2.12.4.3.6]
b. 9 Feb 1685
6
Roger Waters
[1.2.12.4.3.7]
b. 17 Feb 1687
5
Martha Waters
[1.2.12.4.4]
c. 27 Sep 1640
5
John Waters
[1.2.12.4.5]
b. Abt 1654 d. 14 Feb 1706
Sarah Tompkins
b. 1636 d. 1707
6
Richard Waters
[1.2.12.4.5.1]
b. Jun 1664 d. Feb 1725
6
Nathaniel Waters
[1.2.12.4.5.2]
b. 6 Dec 1671 d. 1718
6
Samuel Waters
[1.2.12.4.5.3]
b. 29 Mar 1674 d. 1 May
6
Elizabeth Waters
[1.2.12.4.5.4]
b. 10 Jan 1677 d. 1724
6
Abigail Waters
[1.2.12.4.5.5]
b. 6 May 1683
6
Symond Waters
[1.2.12.4.5.6]
b. 3 Mar 1689
5
Elizabeth Waters
[1.2.12.4.6]
c. 26 Feb 1642 d. 3 Dec 1664
Edmund Bridges
b. 1612 d. 13 Jan 1685
6
John Bridges
[1.2.12.4.6.1]
b. 1644
5
Abigail Waters
[1.2.12.4.7]
c. 18 May 1645 d. Abt 1669
William Punchard
b. 1641 d. 1731
6
Abigail Punchard
[1.2.12.4.7.1]
b. 3 Sep 1670
6
Mary Punchard
[1.2.12.4.7.2]
b. 7 Jan 1673 d. 24 Aug 1678
6
Wiliam Punchard
[1.2.12.4.7.3]
b. Abt 1675 d. 16 Dec 1748
6
John Punchard
[1.2.12.4.7.4]
b. 2 Apr 1682 d. 10 Dec 1740
6
Sarah Punchard
[1.2.12.4.7.5]
b. 27 Oct 1685
5
Mary Waters
[1.2.12.4.8]
b. Abt 1646
Clement English
b. Abt 1640 d. Abt 1682
6
Mary English
[1.2.12.4.8.1]
b. 18 Feb 1668 d. Sep 1702
6
Elizabeth English
[1.2.12.4.8.2]
b. 9 Feb 1671
6
Joseph English
[1.2.12.4.8.3]
b. 12 Mar 1673
6
Benjamin English
[1.2.12.4.8.4]
b. 19 Oct 1678
6
Abigail English
[1.2.12.4.8.5]
b. 6 Dec 1680 d. 1697
6
Clement English
[1.2.12.4.8.6]
b. 7 Mar 1683 d. 7 Mar 1683
+
John Stevens
b. Abt 1640
5
Ezekial Waters
[1.2.12.4.9]
b. 4 Apr 1647 d. 18 Sep 1675
Mary
b. Abt 1650
6
Daniel Waters
[1.2.12.4.9.1]
b. 1675
5
Susannah A Waters
[1.2.12.4.10]
c. 1 Feb 1649 d. 21 Dec 1726
Benedictus Pulsipher
b. 1639 d. 10 Apr 1695
6
Richard Pulsipher
[1.2.12.4.10.1]
b. 31 Mar 1675 d. 25 Mar 1728
6
William Henry Pulsipher
[1.2.12.4.10.2]
b. 12 Dec 1676 d. Not Needed
6
Susanah Pulsipher
[1.2.12.4.10.3]
b. 5 Sep 1678 d. Bef 1689
6
Joseph Pulsipher
[1.2.12.4.10.4]
b. 13 Nov 1680 d. 12 Apr 1711
6
Benjamin Pulsipher
[1.2.12.4.10.5]
b. 19 May 1683 d. 13 Aug 1763
6
David Pulsipher
[1.2.12.4.10.6]
b. 27 Sep 1685 d. 17 Jun 1775
6
Jonathan Pulsipher
[1.2.12.4.10.7]
b. 25 Sep 1687 d. 13 Apr 1763
6
Elizabeth Pulsipher
[1.2.12.4.10.8]
b. 4 Dec 1689 d. 1699
6
Joanna Pulsipher
[1.2.12.4.10.9]
c. 10 May 1691 d. 13 Feb 1766
6
Margaret Pulsipher
[1.2.12.4.10.10]
b. 14 Feb 1694 d. 11 Mar 1744
5
Hannah Waters
[1.2.12.4.11]
b. 20 Feb 1652/1653 d. 21 Dec 1726
5
William Waters
[1.2.12.4.12]
b. 1655 d. Aft 1676
4
Judith Waters
[1.2.12.5]
c. 24 Jan 1607 d. 12 Aug 1609
4
Elizabeth Waters
[1.2.12.6]
b. 9 Dec 1610 d. 29 Aug 1663
John Joseph Lawrence
b. 8 Oct 1609 d. 11 Jul 1667
5
John Lawrence
[1.2.12.6.1]
b. 14 Mar 1635 d. 17 Feb 1712
5
Nathaniel Lawrence
[1.2.12.6.2]
b. 15 Aug 1639 d. 14 Apr 1724
5
Elizabeth Lawrence
[1.2.12.6.3]
b. 16 Jul 1640
5
Joseph Lawrence
[1.2.12.6.4]
b. 30 May 1643 d. Aft 1679
5
Jonathan Lawrence
[1.2.12.6.5]
b. Apr 1644 d. 6 Apr 1648
3
William Manning
[1.2.13]
b. Abt 1568 d. Abt 1607
2
Harry Manning
[1.3]
b. Abt 1522
2
John Manning
[1.4]
b. Abt 1526 d. 1566
2
Joan Manning
[1.5]
b. Abt 1530 d. 1612
+
Robert Pope
b. 1537