Home Page
|
What's New
|
Photos
|
Histories
|
Headstones
|
Reports
|
Surnames
Search
First Name:
Last Name:
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Suomalainen
Svenska
George Manning
1520 - 1582 (62 years)
Submit Photo / Document
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Submit Photo / Doc
Worksheet
Family
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
George Manning
[1]
b. 1520 d. 8 May 1582
Joan Wallis
b. 1524 d. 5 Jun 1582
2
Anne Manning
[1.1]
c. 22 Oct 1545
+
Thomas Lambert
b. Abt 1535 d. 1580
2
Joane Manning
[1.2]
c. 30 Jan 1546
Henry Welsh
b. 1546
3
Henry Welsh
[1.2.1]
b. 1577
2
Katharine Manning
[1.3]
b. 3 Apr 1548 bur. 30 Jun 1596
Hugh Underhill
b. 1519 d. 1593
3
Thomas "Hugh" Underhill
[1.3.1]
b. Abt 1566 d. 1591
3
George Underhill
[1.3.2]
b. Abt 1568 d. 1627
+
Richard Goodman
d. 24 Nov 1611
2
Rose Manning
[1.4]
b. Abt 1551 d. 6 Aug 1554
2
Peter Manning
[1.5]
c. 6 Aug 1553 bur. 10 Dec 1621
Elizabeth Verezelini
b. Abt 1555 d. Feb 1634
3
Jacob Manning
[1.5.1]
b. Abt 1580
3
Nicholas Manning
[1.5.2]
b. Abt 1582
3
Bartholomen Manning
[1.5.3]
b. Abt 1585
3
Henery Manning
[1.5.4]
b. 1588 d. Bef 8 Sep 1632
3
Percivall Manning
[1.5.5]
c. 25 Oct 1590
3
Peter Manning
[1.5.6]
b. Abt 1593
3
George Manning
[1.5.7]
b. Abt 1600
3
Edward Manning
[1.5.8]
c. 28 Dec 1602 bur. 10 Jun 1621
3
Agnes Manning
[1.5.9]
b. Abt 1604
3
Elizabeth Manning
[1.5.10]
b. Abt 1606
2
Elizabeth Manning
[1.6]
c. 6 Aug 1554
+
Griffin Green
b. Abt 1550
2
John Manning
[1.7]
b. 20 Jun 1555 d. Aft 1582
2
George Manning
[1.8]
b. 20 Jun 1555 d. 20 Jun 1555
2
Nicholas Manning
[1.9]
c. 9 Jul 1557 d. 28 Oct 1557
2
Dorothy Manning
[1.10]
b. 3 Oct 1558
John Webb
b. Abt 1554 d. 1 Feb 1625
3
Peter Webb
[1.10.1]
b. Abt 1578
3
Peter Webb
[1.10.2]
b. Abt 1584
3
John Webb
[1.10.3]
b. Abt 1586
3
Ann Webb
[1.10.4]
b. Abt 1588
3
Jane Webb
[1.10.5]
b. Abt 1590
3
John Webb
[1.10.6]
b. Abt 1580
3
Oliph Webb
[1.10.7]
b. Abt 1582
2
Thomas Manning
[1.11]
c. 25 Jan 1561 d. 1594
Miriam Botley
b. Abt 1561 d. 1595
3
Thomas Manning
[1.11.1]
b. Sep 1591 d. 28 Nov 1645
2
Phebe Manning
[1.12]
b. 1566 d. Abt 1642
James Waters
b. Abt 1575 d. 2 Feb 1617
3
Martha Waters
[1.12.1]
b. Abt 1598 bur. 8 Oct 1603
3
Sarah Waters
[1.12.2]
b. 30 Nov 1600 d. 1686
3
Phebe Waters
[1.12.3]
c. 6 Dec 1602 d. 7 Dec 1603
3
Richard John Waters
[1.12.4]
b. 3 Mar 1604 d. 16 Jul 1676
Rejoice Joyce Plasse
b. 1616 d. Abt 1687
4
Sarah Waters
[1.12.4.1]
b. 30 Jun 1637 d. 19 May 1700
Joshua Rea
b. Abt 1628 d. 1710
5
Samuel Rea
[1.12.4.1.1]
b. Abt 1652 d. Abt 1718
Mary Sheldon
b. 15 Jul 1660 d. 31 Mar 1746
6
Samuel Ray
[1.12.4.1.1.1]
b. 12 Mar 1687 d. 2 Sep 1744
6
William Rea
[1.12.4.1.1.2]
b. 18 Apr 1691 d. 21 Aug 1693
6
Daughter Rea
[1.12.4.1.1.3]
b. Dec 1693
6
Robert Rea
[1.12.4.1.1.4]
b. 26 Dec 1695
6
Jonathan Rea
[1.12.4.1.1.5]
b. 9 Jul 1697
6
Benjamin Rea
[1.12.4.1.1.6]
b. 7 Apr 1699
6
Abel Ray
[1.12.4.1.1.7]
b. 6 Jun 1701
6
Elizabeth Rea
[1.12.4.1.1.8]
b. 31 Jul 1703
5
Daniel Rea
[1.12.4.1.2]
b. 30 Mar 1654 d. 5 Mar 1714
Hepzibah Peabody
b. Abt 1652
6
Lemuel Rea
[1.12.4.1.2.1]
b. Abt 1679 d. 1749
6
Jemima Rea
[1.12.4.1.2.2]
b. 29 Dec 1680
6
Daniel Rea
[1.12.4.1.2.3]
b. 23 Nov 1682 d. 1746
6
Zerubabel Rea
[1.12.4.1.2.4]
b. 12 May 1685
6
Elizabeth Rea
[1.12.4.1.2.5]
b. 13 Aug 1687 d. 14 Dec 1711
6
Keturah Rea
[1.12.4.1.2.6]
b. Abt 1689
5
Rebecca Rea
[1.12.4.1.3]
b. 4 Sep 1656 d. 11 Feb 1740
+
John Ballard
b. 17 Jan 1653 d. 18 Dec 1715
5
Sarah Rea
[1.12.4.1.4]
b. 10 Nov 1658
Thomas Haynes
b. Abt 1645 d. 25 Sep 1685
6
John Haynes
[1.12.4.1.4.1]
b. 14 Apr 1678
6
William Haynes
[1.12.4.1.4.2]
b. 25 Aug 1680
6
Sarah Haynes
[1.12.4.1.4.3]
b. 31 Oct 1681
6
Joseph Christopher Haynes
[1.12.4.1.4.4]
b. 1682 d. 1760
6
Benjamin Haynes
[1.12.4.1.4.5]
b. 1685
6
Daniel Haynes
[1.12.4.1.4.6]
b. 1687 d. 1689
6
Hannah Haynes
[1.12.4.1.4.7]
b. 1689
6
Thomas Haynes
[1.12.4.1.4.8]
b. 1690
5
Elizabeth Rea
[1.12.4.1.5]
b. 3 Jan 1660
Joseph Gould
b. 15 Jan 1662 d. 1710
6
Sarah Gould
[1.12.4.1.5.1]
b. 27 Jun 1688 d. 12 Jul 1688
6
Elizabeth Gould
[1.12.4.1.5.2]
b. 27 Jun 1688 d. 12 Jul 1688
6
Daniel Gould
[1.12.4.1.5.3]
b. 1 Dec 1691
6
Zerviah Gould
[1.12.4.1.5.4]
b. 20 Apr 1694 d. Bef 1741
John Sibley
b. 18 Sep 1687 d. 13 May 1741
7
Ebenezer Sibley
[1.12.4.1.5.4.1]
b. 28 Feb 1717 d. 4 Mar 1790
Abigail Cummings
b. 3 May 1716 d. 27 Sep 1783
8
Stephen Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.1]
b. 12 Jul 1741 d. 25 Aug 1828
Thankful Taft
b. 25 May 1745 d. 26 Oct 1837
9
Joel Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.1.1]
b. 25 Apr 1766 d. 10 Apr 1839
Lois Louise Woods
b. 24 Jun 1767 d. 21 Nov 1832
10
Amory Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.1.1.1]
b. 20 Jun 1792 d. 22 Jun 1849
Caroline Bosworth
b. Abt 1796 d. 13 Jan 1858
11
Martha Elmira Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.1.1.1.1]
b. 16 Oct 1839 d. 1 Oct 1920
Harriss de Antignac
b. 7 Oct 1837 d. 22 Jan 1909
12
Caroline de Antignac
[1.12.4.1.5.4.1.1.1.1.1.1]
b. 9 Aug 1857 d. 11 Dec 1934 [
=>
]
10
Josiah Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.1.1.2]
b. 1 Apr 1808 d. 7 Dec 1888
Sarah Ann Sophia Crapon
b. 24 Oct 1809 d. 17 May 1858
11
Samuel Hale Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.1.1.2.1]
b. 9 Sep 1835 d. 1883
Sarah Virginia Hart
b. 22 Oct 1846 d. 3 Jun 1917
12
Josiah Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.1.1.2.1.1]
b. 1866 d. 1879
12
Grace Pendleton Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.1.1.2.1.2]
b. 1868 d. 1870
12
Jennie Hart Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.1.1.2.1.3]
b. 28 Dec 1869
12
Kate Collier Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.1.1.2.1.4]
b. 1872 d. 1921
12
Samuel Hale Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.1.1.2.1.5]
b. 12 Jul 1873 d. 13 Oct 1958 [
=>
]
12
James Hart Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.1.1.2.1.6]
b. 1875
11
William Crapon Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.1.1.2.2]
b. 3 May 1832 d. 17 Apr 1902
Jane Elizabeth Thomas
b. 13 Feb 1838 d. 21 Apr 1930
12
Anne Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.1.1.2.2.1]
b. 11 Mar 1862 d. Jun 1863
12
Josiah Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.1.1.2.2.2]
b. 19 Jan 1864 d. 11 Aug 1866
12
Grigsby Thomas Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.1.1.2.2.3]
b. 21 Dec 1865 d. 1 Aug 1954 [
=>
]
12
Barney Dunbar Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.1.1.2.2.4]
b. 18 Oct 1870 d. 5 Sep 1946 [
=>
]
11
Henry Josiah Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.1.1.2.3]
b. 19 Nov 1833 d. 25 Jul 1864
11
Sophia Matilda Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.1.1.2.4]
b. 16 Oct 1837 d. 29 Oct 1897
+
Charles E Smedes
11
George Royal Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.1.1.2.5]
b. 19 Jul 1839 d. 15 Jul 1895
Emma Susan Hansel Tucker
b. 20 May 1845 d. 1911
12
Alice Reese Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.1.1.2.5.1]
b. 18 Feb 1863 [
=>
]
12
Mary Lois Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.1.1.2.5.2]
b. Feb 1870
12
Annabelle Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.1.1.2.5.3]
b. Sep 1882
12
George Royal Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.1.1.2.5.4]
b. 17 Jun 1884
11
Fannie Maria Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.1.1.2.6]
b. 13 Oct 1841 d. 20 Dec 1842
11
Mary Lois Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.1.1.2.7]
b. 3 Sep 1843 d. 23 Feb 1864
11
Alice Marie Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.1.1.2.8]
b. 9 Feb 1846 d. 13 Jul 1907
+
William T Williams
11
Robert Pendelton Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.1.1.2.9]
b. Abt 1847
Susan Wheless Bolling
b. 19 Jan 1851
12
Bolling Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.1.1.2.9.1]
b. 20 Aug 1873
12
Frances Wheless Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.1.1.2.9.2]
b. 2 Jan 1875
12
Josiah Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.1.1.2.9.3]
b. 12 May 1877 [
=>
]
12
George R Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.1.1.2.9.4]
b. 8 Feb 1879
12
Robert Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.1.1.2.9.5]
b. 28 Mar 1881
12
Herbert Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.1.1.2.9.6]
b. 13 Oct 1885 d. Aug 1904
11
Caroline Crapon Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.1.1.2.10]
b. 21 Feb 1850 d. 16 Nov 1858
11
Amory Walter Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.1.1.2.11]
b. 19 Jun 1852 d. 28 Jul 1899
11
Josiah Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.1.1.2.12]
b. 1866 d. 1879
Emaline Eve
b. 1839
11
John Adam Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.1.1.2.13]
b. 1 Sep 1861 d. 26 Mar 1934
+
Sarah Louise Chandler
11
James Longstreet Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.1.1.2.14]
b. 4 Aug 1863 d. 10 Sep 1945
Martha Erwin
b. 1862 d. 22 Dec 1930
12
Martha Erwin Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.1.1.2.14.1]
b. 13 Feb 1886 d. 10 Aug 1975 [
=>
]
12
John Adams Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.1.1.2.14.2]
b. 4 Jan 1888 d. 25 Oct 1986
12
Ulysses Erwin Maner Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.1.1.2.14.3]
b. 9 Apr 1890 d. 31 Jul 1979
12
James Longstreet Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.1.1.2.14.4]
b. 29 Aug 1891 d. 24 May 1980
12
Josephine King Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.1.1.2.14.5]
b. 13 May 1893 d. 5 May 1980
12
Mary Eve Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.1.1.2.14.6]
b. 28 Nov 1895 d. 14 Dec 1918
12
Josiah Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.1.1.2.14.7]
b. 16 Sep 1898 d. 28 Dec 1965
12
William Augustus Longstreet Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.1.1.2.14.8]
b. 12 Feb 1900 d. 1 Dec 1994
12
Marion Erwin Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.1.1.2.14.9]
b. 12 Jan 1902 d. Jun 1985
12
Alan Bowen Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.1.1.2.14.10]
b. 22 Sep 1903 d. 13 Aug 1990
11
Mary Bones Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.1.1.2.15]
b. 29 Mar 1865 d. 22 Jun 1954
11
Emma Josephine Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.1.1.2.16]
b. 23 Feb 1867 d. 25 Oct 1957
Butler King Couper
b. Abt 1851 d. 20 Oct 1913
12
Constance Maxwell Couper
[1.12.4.1.5.4.1.1.1.2.16.1]
b. 1897 d. 1985
12
Butler King Couper
[1.12.4.1.5.4.1.1.1.2.16.2]
b. 1906 d. 1957
9
Lydia Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.1.2]
b. 2 Apr 1769 d. 27 Nov 1822
Henry Staples Benson
b. 8 Aug 1770 d. 29 Jul 1821
10
Abigail Benson
[1.12.4.1.5.4.1.1.2.1]
b. 31 Mar 1795 d. 10 Nov 1821
Asa Legg
b. 7 May 1792 d. 15 Nov 1836
11
Charlotte Legg
[1.12.4.1.5.4.1.1.2.1.1]
b. 2 May 1818 d. 30 Oct 1900
George Perrier Stawitts
b. 3 Jul 1820 d. 1897
12
Jacob Stawitts
[1.12.4.1.5.4.1.1.2.1.1.1]
b. Abt 1844
12
Cornelius Stanton Stawitts
[1.12.4.1.5.4.1.1.2.1.1.2]
b. 17 Feb 1846 d. 2 May 1914 [
=>
]
12
Herbert Stawitts
[1.12.4.1.5.4.1.1.2.1.1.3]
b. Abt 1848 d. Abt 1852
12
Emma Stawitts
[1.12.4.1.5.4.1.1.2.1.1.4]
b. Abt 1850
11
Lyman Legg
[1.12.4.1.5.4.1.1.2.1.2]
b. 3 Sep 1822 d. 1 Sep 1904
Hannah Thayer
b. 11 Feb 1820
12
Enoch J Legg
[1.12.4.1.5.4.1.1.2.1.2.1]
b. 25 Sep 1846
12
Enda Isadore Legg
[1.12.4.1.5.4.1.1.2.1.2.2]
b. 25 Sep 1846 d. 1 Sep 1914
12
Sarah Thayer Legg
[1.12.4.1.5.4.1.1.2.1.2.3]
b. 20 Oct 1850
10
Harriet Benson
[1.12.4.1.5.4.1.1.2.2]
b. 14 Sep 1796 d. 22 Aug 1852
10
Mellen Benson
[1.12.4.1.5.4.1.1.2.3]
b. 14 Jan 1798
Eliza W Farnum
b. 25 Sep 1802 d. 14 Sep 1839
11
Henry Staples Benson
[1.12.4.1.5.4.1.1.2.3.1]
b. 17 May 1829
11
Almira Farnum Benson
[1.12.4.1.5.4.1.1.2.3.2]
b. 6 Aug 1830 d. 25 Dec 1835
11
James Haskins Benson
[1.12.4.1.5.4.1.1.2.3.3]
b. 16 Oct 1833
11
George Everett Benson
[1.12.4.1.5.4.1.1.2.3.4]
b. 14 Aug 1837
+
Mary Windsor Peck
b. 21 May 1798
10
Hannah Adaline Benson
[1.12.4.1.5.4.1.1.2.4]
b. 12 Aug 1802 d. 19 Jun 1822
10
Rufus Benson
[1.12.4.1.5.4.1.1.2.5]
b. 24 Jan 1804 d. 23 Aug 1805
10
Chloe Ann Benson
[1.12.4.1.5.4.1.1.2.6]
b. 23 Aug 1806
+
Dan Hill
b. 29 Nov 1796
10
Susan Augusta Benson
[1.12.4.1.5.4.1.1.2.7]
b. 9 Oct 1809 d. 25 Jul 1831
Preserved Smith Thayer
b. 9 May 1808
11
Susan Benson Thayer
[1.12.4.1.5.4.1.1.2.7.1]
b. 28 Jun 1831 d. 14 Aug 1909
+
Daniel Wheelock Aldrich
b. 28 Aug 1822 d. 23 May 1891
10
Rufus Aldrich Benson
[1.12.4.1.5.4.1.1.2.8]
b. 9 Oct 1809
+
Sarah E Buell
10
Stephen Sibley Benson
[1.12.4.1.5.4.1.1.2.9]
b. 9 Jan 1810 d. 20 Nov 1869
Elizabeth Richardson Scott
b. 8 Jan 1835 d. 20 Feb 1911
11
Jessie Harriet Benson
[1.12.4.1.5.4.1.1.2.9.1]
b. 7 Jun 1860
+
John Robert Forbes Love
b. 22 Jun 1856
11
Fred Mellen Benson
[1.12.4.1.5.4.1.1.2.9.2]
b. 10 Nov 1862 d. 9 May 1864
11
Susie Adeline Benson
[1.12.4.1.5.4.1.1.2.9.3]
b. 6 Aug 1865
8
Ebenezer Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.2]
b. 9 Oct 1745
Mary Chase
b. 15 Mar 1741 d. 1784
9
Sarah Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.2.1]
b. 19 Dec 1772
9
Lucy Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.2.2]
b. 2 Mar 1775
+
Forbes Bond
b. Abt 1773
9
Eunice Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.2.3]
b. 1 Mar 1777
9
Elias Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.2.4]
b. 8 Aug 1779 d. 1856
Ruth Chase
b. 31 Jan 1780 d. Abt 1858
10
Alonzo Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.2.4.1]
b. 14 Jul 1810 d. 16 Mar 1896
Mary Heath
b. 10 Sep 1813 d. 1836
11
Son Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.2.4.1.1]
b. 20 Oct 1836 d. 5 Dec 1836
Sarah Ann Heath
b. 10 Apr 1812 d. 1873
11
Daughter Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.2.4.1.2]
b. 1838 d. 7 Jul 1838
11
Mary Jane Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.2.4.1.3]
b. 17 Nov 1840 d. 15 Feb 1922
James Pratt
b. May 1835
12
Melville S Pratt
[1.12.4.1.5.4.1.2.4.1.3.1]
b. 5 May 1868 d. 7 Mar 1947
12
Maude Ethlyn Pratt
[1.12.4.1.5.4.1.2.4.1.3.2]
b. 17 Jun 1871 d. 6 Nov 1897
12
Judson Edmond Pratt
[1.12.4.1.5.4.1.2.4.1.3.3]
b. 12 Mar 1885 d. Apr 1972
12
Emma G Pratt
[1.12.4.1.5.4.1.2.4.1.3.4]
b. 23 Jun 1888
11
Harriet A Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.2.4.1.4]
b. 25 Nov 1842 d. 6 Jul 1886
James Bryant Drew
b. 11 Nov 1838 d. 8 Apr 1903
12
Ray Sibley Drew
[1.12.4.1.5.4.1.2.4.1.4.1]
b. 17 Apr 1870 d. 14 Feb 1949 [
=>
]
11
Watson A Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.2.4.1.5]
b. 1844 d. 24 Apr 1924
Margaret H. Hubbell
b. Jul 1849
12
Guy Hubbell Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.2.4.1.5.1]
b. 8 Dec 1872 d. 19 Mar 1936
12
Caroline A Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.2.4.1.5.2]
b. 3 Nov 1874 d. Mar 1976
12
May Viola Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.2.4.1.5.3]
b. 30 Apr 1876
12
Cora I Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.2.4.1.5.4]
b. 11 Jul 1880
11
Judson L Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.2.4.1.6]
b. Oct 1846
Lucia Emma Banks
b. Jun 1851
12
Gertrude R Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.2.4.1.6.1]
b. 6 Nov 1876
+
Adeline Colby
b. 10 Jun 1818 d. 18 Mar 1896
9
Ebenezer Sibley, Jr
[1.12.4.1.5.4.1.2.5]
b. 18 Jan 1782 d. 15 Mar 1827
Polly B Whipple
b. 16 Jun 1791
10
Lorinda Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.2.5.1]
b. 6 Jul 1810
+
Charles Arnold
10
Maria Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.2.5.2]
b. 23 Jul 1812
Whitcomb Gray
b. Abt 1804 d. 10 Jan 1888
11
Delia Maria Gray
[1.12.4.1.5.4.1.2.5.2.1]
b. 1834
+
James Carpenter
b. 1832
11
Mary Ann Grey
[1.12.4.1.5.4.1.2.5.2.2]
c. 20 Mar 1836
+
Moses H. Rumery
b. 1831
10
Polly Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.2.5.3]
b. 11 Sep 1814
10
Mary Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.2.5.4]
b. 8 Mar 1817 d. 17 Jun 1903
Benjamin Cragin
b. 6 Mar 1814 d. 20 Jan 1896
11
Mary Emma Cragin
[1.12.4.1.5.4.1.2.5.4.1]
b. 12 Dec 1839 d. 25 Aug 1924
Joshua Vose
b. 6 Jul 1838 d. 10 Apr 1918
12
Hattie M Vose
[1.12.4.1.5.4.1.2.5.4.1.1]
b. 20 Mar 1869 d. Aft 1930 [
=>
]
12
Mary Louise Vose
[1.12.4.1.5.4.1.2.5.4.1.2]
b. 24 Sep 1875
11
Maria A Cragin
[1.12.4.1.5.4.1.2.5.4.2]
b. 27 Dec 1844
10
Loren Elba Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.2.5.5]
b. 3 May 1821
9
Zadock Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.2.6]
b. 12 Oct 1785
9
Mary Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.2.7]
b. 1 Feb 1789 d. 24 Apr 1844
+
Amos Peirce
b. Abt 1786 d. 22 Dec 1848
8
Abigail Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.3]
b. 22 Jan 1747
8
Peter Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.4]
b. 16 Sep 1749
8
Mary Sibley
[1.12.4.1.5.4.1.5]
b. 20 Jan 1751
7
Stephen Sibley
[1.12.4.1.5.4.2]
b. 1 Oct 1720
Mrs Sibley
b. Abt 1725
8
Elias Sibley
[1.12.4.1.5.4.2.1]
b. Abt 1745
7
Bethiah Sibley
[1.12.4.1.5.4.3]
b. 2 Oct 1724 d. 1 Jul 1756
Samuel Trask
b. 17 Dec 1721 d. 7 Mar 1790
8
John Trask
[1.12.4.1.5.4.3.1]
b. 29 Sep 1744
8
Hannah Trask
[1.12.4.1.5.4.3.2]
b. 10 Nov 1746
8
Sarah Trask
[1.12.4.1.5.4.3.3]
b. 10 Sep 1753 d. 22 Aug 1830
Major Simon Tenney
b. 13 Sep 1746 d. 14 Aug 1838
9
Major Daniel Tenney
[1.12.4.1.5.4.3.3.1]
b. 23 Nov 1773
Betsey Waters
b. 12 Jul 1776 d. 16 Aug 1851
10
Sarah Tenney
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.1]
b. 6 Oct 1797 d. 13 Apr 1880
Edmond John Mills
b. 17 Aug 1791 d. 11 Sep 1889
11
Wiliam Edmund Mills
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.1.1]
b. 2 Nov 1825 d. 18 Dec 1914
Electa Jane Dusenbury
b. 18 Apr 1828 d. 6 Oct 1908
12
Frank Henry Mills
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.1.1.1]
b. 17 Aug 1853 d. 1903 [
=>
]
12
Frances Harriet Mills
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.1.1.2]
b. 17 Aug 1853 d. 1903
12
William Edmond Mills
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.1.1.3]
b. 4 Jul 1855 [
=>
]
11
Nancy Tenney Mills
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.1.2]
b. 15 Mar 1828 d. 12 Jun 1880
Leander C Taylor
b. 1826 d. 12 Jan 1902
12
Elizabeth Jane Taylor
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.1.2.1]
b. Abt 1857 d. 23 Nov 1885
11
Samuel John Mills
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.1.3]
b. 17 Nov 1830 d. 23 Jan 1838
11
Son Mills
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.1.4]
b. 1 Mar 1835 d. 31 Mar 1835
11
Franklin Lewis Mills
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.1.5]
b. 24 Oct 1836 d. 14 Feb 1918
+
Susannah E Kraft
b. Sep 1846 d. 30 Mar 1876
Caroline Morse
b. 23 Apr 1856 d. 1900
12
Sarah Jane Mills
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.1.5.1]
b. 4 Jul 1881 d. 18 Jan 1889
12
Grace Evelyn Mills
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.1.5.2]
b. 7 Nov 1891 d. Aft 1900
11
Sarah Maria Mills
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.1.6]
b. 18 Aug 1841
10
Sally Tenney
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.2]
b. 6 Oct 1797
10
Simon Tenney
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.3]
b. 3 Dec 1799 d. 11 Jun 1856
Nancy Putnam
b. 17 Feb 1800
11
David Tenney
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.3.1]
b. Abt 1830
11
Daniel Tenney
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.3.2]
b. 29 Feb 1832 d. 6 Dec 1844
11
George Tenney
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.3.3]
b. 30 Jan 1837 d. 29 Oct 1839
10
John Waters Tenney
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.4]
b. 25 Jul 1802 d. 29 Apr 1849
Eliza Tileston Fisher
b. 13 May 1803 d. 21 Aug 1847
11
Edward Waters Tenney
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.4.1]
b. Aug 1830
Lucene Ida Haines
b. 8 Oct 1859
12
Lena L Tenny
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.4.1.1]
b. Feb 1879 d. 1942
12
Charles William Tenney
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.4.1.2]
b. 3 Jan 1882
10
Linus Tenney
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.5]
b. 5 Dec 1804
Sally Elwell
b. 2 Dec 1806
11
Charles Linus Tenney
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.5.1]
b. 12 Jan 1829
Catherine Fisk Robbins
b. 1 Nov 1837 d. 8 Feb 1902
12
Edith Frances Tenney
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.5.1.1]
b. 4 Jul 1860 d. 28 Jan 1872
12
Eleanore Amelia Tenney
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.5.1.2]
b. 15 Aug 1862 d. 15 Jan 1865
12
Eva Nena Tenney
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.5.1.3]
b. 8 Apr 1867 d. 12 Nov 1943
12
Lucius E Tenney
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.5.1.4]
b. 22 Jul 1874 d. 1 Jul 1905
12
Rhoda Hannah Tenney
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.5.1.5]
b. 13 Sep 1876
11
George Franklin Tenney
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.5.2]
b. 7 Sep 1831 d. 24 Nov 1831
11
James Henry Tenney
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.5.3]
b. 10 Jun 1838
Arabella Adeline Prichard
b. 11 Oct 1842 d. 22 Mar 1907
12
James Edgar Tenney
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.5.3.1]
b. 2 Apr 1863 d. 6 Jan 1890
12
Florence Mabelle Tenney
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.5.3.2]
b. 10 May 1869 d. 15 Mar 1871
12
Grace Elwell Tenney
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.5.3.3]
b. 10 May 1873
12
Blanche Mack Tenney
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.5.3.4]
b. 27 Sep 1876
12
Ethel Prichard Tenney
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.5.3.5]
b. 18 Dec 1879 d. 6 Jan 1884
10
Nancy Tenney
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.6]
b. 21 Jan 1808 d. 29 May 1822
10
Danial Austin Tenney
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.7]
b. 29 Aug 1811 d. 7 Feb 1871
Marietta Margaret Marcy
b. 11 Jun 1811
11
Daniel Austin Tenney
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.7.1]
b. 15 Oct 1835
Maria Louisa Newton
b. 20 Jul 1843
12
Mary Effie Tenney
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.7.1.1]
b. 12 Jul 1868
12
Ada Mabel Tenney
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.7.1.2]
b. 25 Jan 1870
11
Joseph Starks Tenney
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.7.2]
b. 24 Feb 1838
Emily M Paine
b. Abt 1842
12
George Arthur Tenney
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.7.2.1]
b. 8 Oct 1858
11
George Laban Tenney
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.7.3]
b. 25 Jul 1840
11
Frederick Prescott Tenney
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.7.4]
b. 6 Jul 1845
11
Frank Herbert Tenney
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.7.5]
b. 16 Jan 1849
Ellen Arnold Searles
b. 6 Mar 1847 d. 7 Oct 1904
12
Fannie Augusta Tenney
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.7.5.1]
b. 7 Aug 1878
10
Benjamin Franklin Tenney
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.8]
b. 28 Oct 1813 d. 26 Oct 1900
Frances Bridges Veagie
b. 7 Mar 1819 d. 24 Oct 1858
11
Joseph Franklin Tenney
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.8.1]
b. 12 Nov 1838 d. 1878
Mary Bowman Viles
b. 17 Feb 1831
11
Frank Tenney
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.8.2]
b. 4 Feb 1861
11
Arthur Tenney
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.8.3]
b. 1 Jun 1863 d. 16 Jun 1866
11
Maud Tenney
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.8.4]
b. 13 May 1875 d. 30 Jun 1896
Frank Foster Sherburne
12
Ruth Sherburne
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.8.4.1]
b. 18 Jun 1893
12
Elizabeth Sherburne
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.8.4.2]
b. 25 Jul 1894
12
Tenny Sherburne
[1.12.4.1.5.4.3.3.1.8.4.3]
b. 24 Jun 1899
8
Samuel Trask, Jr
[1.12.4.1.5.4.3.4]
b. 26 Aug 1749
Ruth Tenney
b. 16 Mar 1753 d. 27 Apr 1789
9
Samuel Trask, III
[1.12.4.1.5.4.3.4.1]
b. 10 Dec 1773
9
Simon Trask
[1.12.4.1.5.4.3.4.2]
b. 13 Jan 1775
9
Hannah Trask
[1.12.4.1.5.4.3.4.3]
b. 4 Feb 1777
9
Stephen Trask
[1.12.4.1.5.4.3.4.4]
b. 18 Feb 1779
9
Salley Trask
[1.12.4.1.5.4.3.4.5]
b. 17 Jan 1784 d. 5 Feb 1819
Elijah Holman
10
Jonathan Holman
[1.12.4.1.5.4.3.4.5.1]
b. 21 Jun 1813 d. 24 Oct 1816
10
Sarah Trask Holman
[1.12.4.1.5.4.3.4.5.2]
b. 16 May 1816 d. 8 May 1847
Sherman Hale
b. Abt 1812
11
Anna Hale
[1.12.4.1.5.4.3.4.5.2.1]
b. Abt 1838
11
Ann Hale
[1.12.4.1.5.4.3.4.5.2.2]
b. 1840
11
Emily Hale
[1.12.4.1.5.4.3.4.5.2.3]
b. Jul 1841 d. 2 Nov 1906
11
Anna H Hale
[1.12.4.1.5.4.3.4.5.2.4]
b. Feb 1843 d. 5 Jan 1929
11
Sarah Frank Hale
[1.12.4.1.5.4.3.4.5.2.5]
b. 16 Dec 1844 d. 30 Oct 1933
11
Charles T H Hale
[1.12.4.1.5.4.3.4.5.2.6]
b. 1846
10
Son Holman
[1.12.4.1.5.4.3.4.5.3]
b. Abt 1819 d. 23 Feb 1826
Allice Perry
b. Abt 1759
9
Talmon Trask
[1.12.4.1.5.4.3.4.6]
c. 6 Oct 1799
9
Danforth Trask
[1.12.4.1.5.4.3.4.7]
c. 27 Nov 1801
9
Dexter Trask
[1.12.4.1.5.4.3.4.8]
c. 11 Aug 1807
9
Edwin Trask
[1.12.4.1.5.4.3.4.9]
c. 29 Sep 1809
9
Angelina Trask
[1.12.4.1.5.4.3.4.10]
c. 26 Oct 1811
8
Anne Trask
[1.12.4.1.5.4.3.5]
b. 9 Oct 1757
7
Timothy Sibley
[1.12.4.1.5.4.4]
b. 2 Nov 1727 d. 6 Dec 1818
Ann Waite
b. 14 Oct 1733 d. 12 Mar 1791
8
John Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.1]
b. 19 May 1757 d. 8 Apr 1837
Betsey Hopkins
b. Abt 1754 d. 1790
9
George Champlin Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.1.1]
b. 1 Apr 1782 d. 31 Jan 1863
+
Mary Smith Easton
b. 24 Jan 1800 d. 20 Jun 1878
8
Timothy Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2]
b. 19 Jun 1754 d. 26 Aug 1829
Mary
b. Abt 1756
9
Timothy Willard Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.1]
b. 11 Sep 1779 d. 11 Mar 1820
Elizabeth Comins
d. 2 Mar 1820
10
William C Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.1.1]
b. 20 Jun 1812
10
Sarah Elizabeth Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.1.2]
b. 2 Jan 1814
10
Mary Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.1.3]
b. 26 Sep 1815
10
Amanda M Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.1.4]
b. 25 Jun 1817
10
Nancy W Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.1.5]
b. 10 Jul 1819
Francis S Putney
b. 20 Oct 1818
11
William Frank Putney
[1.12.4.1.5.4.4.2.1.5.1]
b. 23 Sep 1844 d. 11 Feb 1847
11
Frank Edward Putney
[1.12.4.1.5.4.4.2.1.5.2]
b. 12 Apr 1847 d. Dec 1849
11
William Sibley Putney
[1.12.4.1.5.4.4.2.1.5.3]
b. 24 Mar 1849 d. 16 Jan 1933
+
Lavina Jane Call
b. 14 Aug 1852
11
Clara A Putney
[1.12.4.1.5.4.4.2.1.5.4]
b. 28 Sep 1850
11
Mary Ann Putney
[1.12.4.1.5.4.4.2.1.5.5]
b. 25 Dec 1852 d. 13 May 1881
Sheldon M Scribner
b. 22 Sep 1848
12
Howard S Scribner
[1.12.4.1.5.4.4.2.1.5.5.1]
b. 29 Jul 1876
12
Harlan W Scribner
[1.12.4.1.5.4.4.2.1.5.5.2]
b. 6 Mar 1878
12
Orrin F Scribner
[1.12.4.1.5.4.4.2.1.5.5.3]
b. 23 Sep 1879 d. 10 Jul 1880
11
Josephine E Putney
[1.12.4.1.5.4.4.2.1.5.6]
b. 16 Dec 1854 d. 26 Dec 1857
11
Orrin F Putney
[1.12.4.1.5.4.4.2.1.5.7]
b. 20 Dec 1856 d. 20 Mar 1881
11
Luther C Putney
[1.12.4.1.5.4.4.2.1.5.8]
b. 26 Jul 1859 d. 1920
Anna P Wadleigh
b. 11 Oct 1868 d. 6 Aug 1894
12
Winnifred Maude Putney
[1.12.4.1.5.4.4.2.1.5.8.1]
b. 8 Oct 1893
11
Fred Willard Putney
[1.12.4.1.5.4.4.2.1.5.9]
b. 21 Jan 1866 d. 26 Dec 1930
Evelyn Angusta Breed
b. 26 Mar 1869 d. 19 May 1932
12
Luther Roy Putney
[1.12.4.1.5.4.4.2.1.5.9.1]
b. 10 Jun 1890
10
Almira S Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.1.6]
9
Mary Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.2]
b. 5 Dec 1780
+
Amariah Scarboro
9
Anne Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.3]
b. 15 Jan 1782
9
Cyrus Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.4]
b. 6 Jan 1784
Eliza Ann Humphries
b. 9 Sep 1809 d. 4 Oct 1884
10
Artemas Origin Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.4.1]
b. 9 Mar 1829
Eloise Soria
11
Robert A Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.4.1.1]
b. 25 Nov 1855 d. 18 Jul 1902
11
Artemise Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.4.1.2]
b. 1861
11
Eugene Walter Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.4.1.3]
b. 25 Mar 1865 d. 23 Apr 1945
Florence Cleora D'Olive
12
Florence Eloise Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.4.1.3.1]
b. 9 Aug 1890 d. 14 Jun 1983
12
Eugene Soria Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.4.1.3.2]
b. 9 Jul 1892 d. 9 Sep 1960
12
Cyrus Rufus Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.4.1.3.3]
b. 18 Oct 1896 d. 11 Sep 1939
12
William Fonde Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.4.1.3.4]
b. 1904 d. 19 Nov 1937 [
=>
]
12
Vernon Lynnwood Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.4.1.3.5]
b. 23 Sep 1907 d. 25 Jul 1974
11
Cyrus Artemas Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.4.1.4]
b. 25 Aug 1866 d. 25 Aug 1949
Elizabeth O'Conner
b. 2 Apr 1883 d. 19 Nov 1970
12
Cyrus Artemus Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.4.1.4.1]
b. 1904
11
Hattie S Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.4.1.5]
b. 1870
11
Annie Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.4.1.6]
b. 1872
11
William Soria Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.4.1.7]
b. 12 Sep 1874 d. 12 Feb 1968
10
Salome Jane Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.4.2]
b. 19 Dec 1829 d. 12 Apr 1835
10
Artemesia Ann Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.4.3]
b. 31 Jul 1830 d. 1 Sep 1903
Robert Brown Searing
b. 15 May 1829 d. 2 May 1890
11
Robert Brian Searing
[1.12.4.1.5.4.4.2.4.3.1]
b. 1859 d. 1878
11
Harry Pond Searing
[1.12.4.1.5.4.4.2.4.3.2]
b. 1863 d. 20 Dec 1873
11
Cyrus Sibley Searing
[1.12.4.1.5.4.4.2.4.3.3]
11
Florence Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.4.3.4]
11
Theodore Searing
[1.12.4.1.5.4.4.2.4.3.5]
10
Willard Franklin Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.4.4]
b. 18 Apr 1835
10
Cyrus Blue Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.4.5]
b. 18 Apr 1837
10
Helena Jane Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.4.6]
b. 27 May 1839
10
Henrietta Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.4.7]
b. 1842 d. 6 Feb 1892
10
Walter Howard Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.4.8]
10
Augustus Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.4.9]
9
Artemas Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.5]
b. 21 Apr 1786
9
Salome Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.6]
b. 13 Apr 1788 d. Aft 1880
Elijah Jewett
b. 8 Feb 1782 d. 1879
10
John F Jewett
[1.12.4.1.5.4.4.2.6.1]
b. 1817
+
Elizabeth How
b. Abt 1819
10
Origin Sibley Jewett
[1.12.4.1.5.4.4.2.6.2]
b. 20 Apr 1820 d. 19 Sep 1863
Clara Lee James
b. 25 Oct 1832 d. 1912
11
Origin Sibley Jewett
[1.12.4.1.5.4.4.2.6.2.1]
b. 1860 d. 1908
Virginia Flinn
b. 26 Jul 1871 d. 17 Apr 1942
12
Son Jewett
[1.12.4.1.5.4.4.2.6.2.1.1]
b. 12 Dec 1905 d. 12 Dec 1905
10
Mary Elizabeth Jewett
[1.12.4.1.5.4.4.2.6.3]
b. Abt 1821 d. 1901
Armistead M Elgin
b. 1819
11
Isabella Elgin
[1.12.4.1.5.4.4.2.6.3.1]
b. 20 May 1857 d. 30 May 1924
Cornelius E Thames
b. 1859
12
Armistead Elgin Thames
[1.12.4.1.5.4.4.2.6.3.1.1]
b. Abt 1884 d. 22 Jan 1964
12
Cornelius E Thames, Jr
[1.12.4.1.5.4.4.2.6.3.1.2]
b. Abt 1886 d. Aft 1940
12
Eugene Thames
[1.12.4.1.5.4.4.2.6.3.1.3]
b. Abt 1889 d. 8 Jun 1942 [
=>
]
11
Willie A Elgin
[1.12.4.1.5.4.4.2.6.3.2]
b. 18 Jan 1860 d. 12 Apr 1875
11
Clara J Elgin
[1.12.4.1.5.4.4.2.6.3.3]
b. Abt 1863 d. 25 Apr 1959
+
John H Fitzpatrick
b. Abt 1860
11
Elizabeth May Elgin
[1.12.4.1.5.4.4.2.6.3.4]
b. 1867 d. 24 Jan 1936
+
Edward Gray Caufman
b. 17 Sep 1834 d. 5 Mar 1907
9
Benijamin Franklin Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.7]
b. 19 Jul 1790
9
Origen Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.8]
b. 1792 d. 1870
Elizabeth Barlow
b. 8 May 1815 d. 2 Jul 1875
10
Josephine Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.1]
b. 2 Jul 1835 d. 3 Mar 1873
George W Barnaby
d. 1859
11
Bessie Barnaby
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.1.1]
b. 14 Jan 1857
+
Martin Kent Northam
11
George Adam Barnaby
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.1.2]
b. 14 Jan 1857 d. 1897
William Motley Stevens
d. 1870
11
Lloyd Motley Stevens
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.1.3]
b. 13 Jan 1869 d. 13 Jun 1955
10
Salome Elizabeth Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.2]
b. 19 Aug 1837 d. 1 Nov 1893
Nathaniel Ragan King
b. 18 Jun 1831 d. 19 Nov 1863
11
Marietta King
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.2.1]
b. 8 Sep 1858
William M King
12
Harvey King
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.2.1.1]
b. 16 Jul 1891
11
Sibley Paul King
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.2.2]
b. 5 Jun 1860
11
Idyl King
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.2.3]
b. 23 Feb 1862
William Edwin Gorsby
12
Paul Clinton Gorsby
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.2.3.1]
11
Nathalie Ragan King
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.2.4]
b. 6 May 1863
Charles Friend Warriner
b. 28 Jan 1855
12
Olga G Warriner
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.2.4.1]
b. 14 Jan 1889
12
Nathalie Warriner
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.2.4.2]
b. 17 Jan 1890
12
Mabel Warriner
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.2.4.3]
b. 6 Mar 1891
12
Laura Salome Warriner
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.2.4.4]
b. 1893
10
Origen Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.3]
b. 6 Feb 1840
Harriet A Brainerd
b. 1 Feb 1845
11
James Brainard Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.3.1]
b. 15 May 1869
+
Adele Estelle Ward
11
Origen Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.3.2]
b. 30 Jun 1872
11
Orlean Emma Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.3.3]
b. 30 Jun 1872 d. 27 Oct 1872
11
Will Owen Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.3.4]
b. 1 May 1880 d. 13 Aug 1880
10
Laura Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.4]
b. 1842
William G McNeill
11
Mary Elizabeth McNeill
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.4.1]
b. 8 Mar 1865
Ludolph Chester
12
Alan Chester
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.4.1.1]
11
William Stoddard McNeill
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.4.2]
b. 6 Dec 1866 d. 14 Apr 1868
11
Laurence Harvey McNeill
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.4.3]
b. 10 Aug 1869
11
Fanny Ethel McNeill
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.4.4]
b. 21 May 1871
11
Daniel McNeill
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.4.5]
b. 22 Sep 1872
11
Lila Douglas McNeill
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.4.6]
b. 10 Apr 1877 d. 1954
10
Franklin Edward Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.5]
b. 1844
Ida K Sterne
11
Helen May Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.5.1]
b. 1879 d. 1880
11
Frank Eillott Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.5.2]
b. 1881 d. 1943
11
Ida Valerie Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.5.3]
b. 1883 d. 1979
11
Julian Dannis Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.5.4]
b. 1885 d. 1964
11
Rowland Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.5.5]
b. 1890 d. 1901
10
Helen Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.6]
b. 15 Dec 1846 d. 1940
Audubon Gullette
11
Laura Helen Gullette
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.6.1]
b. 30 Oct 1867
Samuel Barlow
b. Abt 1867
12
Nellie Barlow
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.6.1.1]
b. 1888
11
Elizabeth Gullette
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.6.2]
b. 1869
+
Albert Putnam
11
Eugenia Gullette
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.6.3]
b. 9 Mar 1874
+
Samuel Cad Wallader Dodge
10
Charles Sweet Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.7]
b. 25 Jan 1849
Edna G D'Olive
b. 1872
11
Edna Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.7.1]
b. Dec 1890 d. 1987
10
Eugene Wilson Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.8]
b. 16 Sep 1851 d. 4 Mar 1911
Minnie M Sterne
11
Edward Austin Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.8.1]
d. 1960
11
Elizabeth Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.8.2]
d. 1896
11
Laurence Sterne Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.8.3]
d. 1901
10
Guy Clarence Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.9]
b. 1855
Susie Witherspoon Shipman
b. 29 Apr 1858 d. 27 Mar 1934
11
Guy Clarence Shipley, Jr
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.9.1]
b. 28 Jan 1883 d. 21 Feb 1912
10
Julia Eve Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.10]
b. 16 Jan 1856
Edward L Barnes
b. 23 Jan 1850
11
Anderson Barnes
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.10.1]
b. 28 Oct 1877
+
Olga Warines
b. 1889
11
Origen Sibley Barnes
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.10.2]
b. 2 Sep 1879 d. 1884
11
Edward L Barnes
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.10.3]
+
Annie
11
Pendleton Barnes
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.10.4]
11
Sager Barnes
[1.12.4.1.5.4.4.2.8.10.5]
8
Joshua Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.3]
b. 16 Nov 1755 d. 29 Sep 1774
8
Stephen Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.4]
b. 19 May 1757 d. 2 Jun 1759
8
Stephen Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.5]
b. 10 Nov 1759 d. 21 Apr 1829
8
Ebenezer Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.6]
b. 7 Apr 1761 d. 10 Sep 1839
Lydia Beach
b. 15 May 1766 d. 6 Mar 1834
9
John Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.6.1]
b. 3 Jul 1791
Nancy Kellog
b. 12 Mar 1809 d. 13 Jun 1885
10
Huldah Ann Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.6.1.1]
b. 13 Dec 1839 d. 30 Aug 1874
Carlos C Martin
b. 28 Dec 1819 d. 23 Oct 1894
11
Carlos Sibley Martin
[1.12.4.1.5.4.4.6.1.1.1]
b. 22 Jul 1866 d. 19 Jun 1952
Sylvia Alice Hazard
b. 12 Apr 1869 d. 18 Oct 1938
12
Anna Caroline Martin
[1.12.4.1.5.4.4.6.1.1.1.1]
b. 16 Aug 1902 d. 22 Nov 1986
11
George Chapman Martin
[1.12.4.1.5.4.4.6.1.1.2]
b. 17 May 1868 d. 23 Jun 1921
+
Marrian Lane
b. 1871
10
Ebenezer Kellogg Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.6.1.2]
b. 21 Sep 1841 d. 29 Sep 1895
+
Ellen Welty
b. 21 Jul 1848 d. 8 Sep 1931
10
George Whitney Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.6.1.3]
b. 17 Jan 1843 d. 7 Jul 1911
Mary L Woodward
b. 21 Sep 1845 d. 1 Jan 1876
11
George Woodward Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.6.1.3.1]
b. 2 Apr 1869 d. 3 Nov 1941
Louella Irene Bright
b. 25 Aug 1858 d. 23 Apr 1926
12
Luella Marie Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.6.1.3.1.1]
b. 11 Oct 1895 d. 12 Apr 1984 [
=>
]
12
Frederick Woodward Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.6.1.3.1.2]
b. 26 Jan 1912 d. 29 Jul 1925
12
George Allen Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.6.1.3.1.3]
b. 14 Jan 1913 d. 23 Jul 1983 [
=>
]
12
Edwin Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.6.1.3.1.4]
b. 24 Jun 1919 d. 16 Dec 1935
Hedwig Fredrick
b. 11 Apr 1879
12
Frederick Woodward Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.6.1.3.1.5]
b. 26 Jan 1912 d. 29 Jul 1925
12
George Allen Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.6.1.3.1.6]
b. 14 Jan 1913 d. 23 Jul 1983 [
=>
]
12
Edwin Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.6.1.3.1.7]
b. 24 Jun 1919 d. 16 Dec 1935
11
John Whitney Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.6.1.3.2]
b. 19 Jan 1875
Reteena Jasmine Sanders
b. 26 Apr 1850 d. 2 Jun 1929
11
Anna May Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.6.1.3.3]
b. 28 Oct 1879 d. 4 Sep 1962
David Welty Divine
b. 9 Nov 1867 d. 11 Jul 1935
12
Elizabeth Sibley Divine
[1.12.4.1.5.4.4.6.1.3.3.1]
b. 8 Sep 1909 d. 30 May 1992
12
William Welty Divine
[1.12.4.1.5.4.4.6.1.3.3.2]
b. 18 May 1912 d. 10 Mar 1984
12
George Whitney Divine
[1.12.4.1.5.4.4.6.1.3.3.3]
b. 30 Nov 1914 d. 27 Dec 1982
+
Victor S Yarros
b. 8 Apr 1865 d. 30 Oct 1956
11
Elizabeth Kellogg Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.6.1.3.4]
b. 29 Aug 1884 d. 6 Sep 1943
+
Edgar Allen Truby
b. 6 Dec 1872 d. 12 Mar 1921
11
John Whitney Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.6.1.3.5]
b. 17 Mar 1886 d. 29 Jul 1976
+
Marion Augusta Simmons
b. Abt 1886 d. 12 Dec 1978
10
John Nelson Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.6.1.4]
b. 10 Nov 1844 d. 4 Jan 1880
10
Benjamin Franklin Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.6.1.5]
b. 5 Aug 1846 d. 1907
Lucia Marion Hill
b. 27 Dec 1848
11
Delia M Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.6.1.5.1]
b. 1874 d. 1876
11
William H Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.6.1.5.2]
b. 1877 d. 1888
11
Arthur K Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.6.1.5.3]
b. 1882 d. 1888
11
Hiram W Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.6.1.5.4]
b. 1884 d. 1886
11
George H Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.6.1.5.5]
b. 1892 d. 1893
10
Hiram Beach Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.6.1.6]
b. 4 Mar 1849 d. 20 Sep 1876
+
Mary Ann Wheeler
b. 13 Apr 1851 d. 25 Jan 1926
9
Timothy Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.6.2]
b. 4 Feb 1803 d. 24 Sep 1880
8
Anna Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.7]
b. 15 Dec 1762 d. 17 Sep 1792
Samuel Hoyt
b. 24 Jan 1739 d. 22 Nov 1821
9
Lydia Hoyt
[1.12.4.1.5.4.4.7.1]
b. 9 Apr 1779 d. Aft 1850
Jonathan Bean
b. 26 Feb 1776 d. 9 Nov 1844
10
Sopia Bean
[1.12.4.1.5.4.4.7.1.1]
b. 16 Jun 1799
10
Fanny Bean
[1.12.4.1.5.4.4.7.1.2]
b. 20 Jan 1801
10
Otis Bean
[1.12.4.1.5.4.4.7.1.3]
b. 26 Dec 1802
10
Asa Bean
[1.12.4.1.5.4.4.7.1.4]
b. 13 Mar 1805 d. 18 Apr 1856
Jane D Stone
b. 20 Jan 1820 d. 30 Jul 1896
11
Leenze Bean
[1.12.4.1.5.4.4.7.1.4.1]
b. 4 Sep 1840 d. 1 Mar 1841
11
Julia Ann Judson Bean
[1.12.4.1.5.4.4.7.1.4.2]
b. 15 Feb 1842 d. 7 Jul 1927
11
Adeniran Judson Bean
[1.12.4.1.5.4.4.7.1.4.3]
b. Abt 1843 d. 12 Jun 1888
+
Larzetta Anderson
b. 11 Dec 1849 d. 2 Feb 1875
+
Kate Kirkwood
11
Harriet Newell Bean
[1.12.4.1.5.4.4.7.1.4.4]
b. 21 Jun 1847 d. 25 Dec 1928
+
George W Simmons
11
William Gustin Bean
[1.12.4.1.5.4.4.7.1.4.5]
b. 8 Jan 1850 d. 5 Apr 1850
11
Fanny Jeanette Bean
[1.12.4.1.5.4.4.7.1.4.6]
b. 28 May 1852
Albion F Pearson
b. 1850 d. 1882
12
Nettie Alice Pearsons
[1.12.4.1.5.4.4.7.1.4.6.1]
b. 14 Feb 1871 d. 7 Jul 1951 [
=>
]
12
Lillian P Pearson
[1.12.4.1.5.4.4.7.1.4.6.2]
b. 10 Sep 1877
12
Albion N Pearson
[1.12.4.1.5.4.4.7.1.4.6.3]
b. 3 Dec
+
J C Mann
d. 29 Oct 1897
11
Margaret Jane Bean
[1.12.4.1.5.4.4.7.1.4.7]
b. 6 Mar 1855
+
Vincent Francis
d. 3 Jul 1897
+
William Housel
10
Synthia Bean
[1.12.4.1.5.4.4.7.1.5]
b. 26 Dec 1807 d. 15 Oct 1816
10
Eliza Bean
[1.12.4.1.5.4.4.7.1.6]
b. 26 Dec 1807 d. 15 Oct 1816
10
Rueben C Bean
[1.12.4.1.5.4.4.7.1.7]
b. 2 Apr 1809
+
Elizabeth
10
Ann Bean
[1.12.4.1.5.4.4.7.1.8]
b. 22 May 1811
10
Mary Bean
[1.12.4.1.5.4.4.7.1.9]
b. 2 May 1813
10
Martha Bean
[1.12.4.1.5.4.4.7.1.10]
b. 15 Dec 1815 d. 6 Jan 1818
9
Anna Hoyt
[1.12.4.1.5.4.4.7.2]
b. 26 Sep 1781 d. 16 Sep 1865
Paulus Tenney
b. 24 Sep 1781 d. 29 Sep 1841
10
Maria Tenney
[1.12.4.1.5.4.4.7.2.1]
b. 4 Jun 1805 d. 1 May 1812
10
Franklin Tenney
[1.12.4.1.5.4.4.7.2.2]
b. 5 Nov 1806 d. 15 Nov 1878
10
Nancy S Tenney
[1.12.4.1.5.4.4.7.2.3]
b. 28 Oct 1808 d. 1885
James French
b. 1 Apr 1815
11
Rebecca Ann French
[1.12.4.1.5.4.4.7.2.3.1]
b. 26 Jan 1838
11
James Paulus French
[1.12.4.1.5.4.4.7.2.3.2]
b. 4 Apr 1840
11
Mary Elizabeth French
[1.12.4.1.5.4.4.7.2.3.3]
b. 24 Aug 1842
+
Oscar E Boyd
b. Abt 1838
11
Jonathan John French
[1.12.4.1.5.4.4.7.2.3.4]
b. 31 Jan 1845
11
Samuel S French
[1.12.4.1.5.4.4.7.2.3.5]
b. 21 Dec 1847 d. 12 Jan 1851
11
William Harris French
[1.12.4.1.5.4.4.7.2.3.6]
b. 29 Oct 1850 d. 11 Jan 1851
11
Solon Tenney French
[1.12.4.1.5.4.4.7.2.3.7]
b. 15 Oct 1851 d. 27 Dec 1908
+
Laura Augusta Shumway
b. 21 Aug 1854
10
Sylvainus Tenny
[1.12.4.1.5.4.4.7.2.4]
b. 6 Oct 1810 d. 12 Oct 1888
Mary Jane Bay
b. 21 Mar 1818
11
Paul Hugh Tenney
[1.12.4.1.5.4.4.7.2.4.1]
b. 1 May 1839 d. 29 Sep 1868
Angeline
b. Abt 1843
12
Mary Tenney
[1.12.4.1.5.4.4.7.2.4.1.1]
b. 1864
12
George S Tenney
[1.12.4.1.5.4.4.7.2.4.1.2]
b. 1866
11
Arkalon Tenney
[1.12.4.1.5.4.4.7.2.4.2]
b. 26 Jun 1841
Margaret Shields
b. Abt 1841
12
Laura A Tenney
[1.12.4.1.5.4.4.7.2.4.2.1]
b. 4 Dec 1860 d. 29 Aug 1876
12
Hosea Eugene Tenney
[1.12.4.1.5.4.4.7.2.4.2.2]
b. 28 Mar 1863 d. 7 Dec 1936 [
=>
]
12
William Sheridan Tenney
[1.12.4.1.5.4.4.7.2.4.2.3]
b. 8 Oct 1865 d. 7 Oct 1876
12
Mary Eliza Tenney
[1.12.4.1.5.4.4.7.2.4.2.4]
b. 21 Feb 1868
12
Leila May Tenney
[1.12.4.1.5.4.4.7.2.4.2.5]
b. 23 Feb 1871
12
Mattie A Tenney
[1.12.4.1.5.4.4.7.2.4.2.6]
b. 25 Oct 1874
12
James Garfield Morton Tenney
[1.12.4.1.5.4.4.7.2.4.2.7]
b. 7 Nov 1881 d. 1970
11
Curtis Monroe Tenney
[1.12.4.1.5.4.4.7.2.4.3]
b. 2 Aug 1847 d. 10 Dec 1850
11
William Lafayette Tenney
[1.12.4.1.5.4.4.7.2.4.4]
b. 30 Apr 1851
Mary Ann Turner
b. Jun 1851
12
Leslie Edward Tenney
[1.12.4.1.5.4.4.7.2.4.4.1]
b. 5 Dec 1873
12
Lieuellon Tenney
[1.12.4.1.5.4.4.7.2.4.4.2]
b. Jun 1875
12
Gracy A Tenney
[1.12.4.1.5.4.4.7.2.4.4.3]
b. Feb 1880
12
William L Tenney
[1.12.4.1.5.4.4.7.2.4.4.4]
b. Feb 1883
12
Minnie M Tenney
[1.12.4.1.5.4.4.7.2.4.4.5]
b. Oct 1885
12
Mary J Tenney
[1.12.4.1.5.4.4.7.2.4.4.6]
b. Jun 1889
12
Hershel A Tenney
[1.12.4.1.5.4.4.7.2.4.4.7]
b. Apr 1891
12
Beatrice Leone Tenney
[1.12.4.1.5.4.4.7.2.4.4.8]
b. 6 Jun 1893
11
Zilpha Tenney
[1.12.4.1.5.4.4.7.2.4.5]
b. 1853 d. 1856
11
Mary Mariah Tenney
[1.12.4.1.5.4.4.7.2.4.6]
b. 4 Sep 1844 d. 15 Jan 1933
Isaac Wood
b. 6 May 1843 d. 1 May 1927
12
Nettie Ambrosia Wood
[1.12.4.1.5.4.4.7.2.4.6.1]
b. 10 Nov 1863 d. 31 Oct 1892
12
Effie Alberta Wood
[1.12.4.1.5.4.4.7.2.4.6.2]
b. 19 Jul 1866 [
=>
]
12
Ivia Jane Wood
[1.12.4.1.5.4.4.7.2.4.6.3]
b. 1870 d. 1963
12
Earnest Doric Wood
[1.12.4.1.5.4.4.7.2.4.6.4]
b. 20 Jan 1874 d. 1939
12
Arkalon John Wood
[1.12.4.1.5.4.4.7.2.4.6.5]
b. 24 Dec 1875 d. 2 Feb 1958 [
=>
]
12
Lillian Grace Wood
[1.12.4.1.5.4.4.7.2.4.6.6]
b. 24 Jan 1879 d. 24 Jan 1879
12
Bessie Kate Wood
[1.12.4.1.5.4.4.7.2.4.6.7]
b. 13 Dec 1881 d. 12 Nov 1977 [
=>
]
12
Zilpha L Wood
[1.12.4.1.5.4.4.7.2.4.6.8]
b. 1883 d. 30 Jun 1986
12
Adda May Wood
[1.12.4.1.5.4.4.7.2.4.6.9]
b. 1883
11
James F Tenney
[1.12.4.1.5.4.4.7.2.4.7]
b. 1856
Martha Ann Austin
b. Jul 1857
12
Maud Tenney
[1.12.4.1.5.4.4.7.2.4.7.1]
b. Oct 1877
12
Sylvanus Tenney
[1.12.4.1.5.4.4.7.2.4.7.2]
b. Mar 1879
12
Martin Tenney
[1.12.4.1.5.4.4.7.2.4.7.3]
b. Jul 1883
12
Frank Tenney
[1.12.4.1.5.4.4.7.2.4.7.4]
b. Dec 1885
12
Otha Tenney
[1.12.4.1.5.4.4.7.2.4.7.5]
b. Aug 1888
12
Edmund Tenney
[1.12.4.1.5.4.4.7.2.4.7.6]
b. Feb 1890
12
Florence M Tenney
[1.12.4.1.5.4.4.7.2.4.7.7]
b. Dec 1894
9
William Hoyt
[1.12.4.1.5.4.4.7.3]
b. 24 Jul 1783 d. 19 Feb 1813
Polly French
b. Abt 1785
10
Freeman Hoyt
[1.12.4.1.5.4.4.7.3.1]
b. 1805
10
Mary French Hoyt
[1.12.4.1.5.4.4.7.3.2]
b. Abt 1809
+
Cheney
b. Abt 1845
10
Sewell Hoyt
[1.12.4.1.5.4.4.7.3.3]
b. Abt 1811
10
William Hoyt
[1.12.4.1.5.4.4.7.3.4]
b. Abt 1813
10
French Hoyt
[1.12.4.1.5.4.4.7.3.5]
b. Abt 1815
9
Sarah Hoyt
[1.12.4.1.5.4.4.7.4]
b. 13 Feb 1786 d. 14 Nov 1862
John Hoyt
b. 2 Dec 1787
10
Sophronia Hoyt
[1.12.4.1.5.4.4.7.4.1]
b. 21 Dec 1810 d. 12 Feb 1889
Joel Blackman
b. 21 Dec 1810 d. 22 Jun 1901
11
True Worthy Blackman
[1.12.4.1.5.4.4.7.4.1.1]
b. 27 Nov 1836 d. 16 Jan 1925
Amelia Fanny Kennedy
b. 10 Jul 1848 d. 8 Dec 1914
12
Albert Joseph Blackman
[1.12.4.1.5.4.4.7.4.1.1.1]
b. 14 Oct 1873 d. 15 Sep 1962
12
Alexander Frances Blackman
[1.12.4.1.5.4.4.7.4.1.1.2]
b. 5 May 1876 [
=>
]
11
John Monroe Blackman
[1.12.4.1.5.4.4.7.4.1.2]
b. 1852 d. 7 Jun 1871
11
Virgil W Blackman
[1.12.4.1.5.4.4.7.4.1.3]
b. 3 Jul 1857 d. 1921
Delle Lucretia Butler
b. Apr 1862 d. 1959
12
Hattie Blackman
[1.12.4.1.5.4.4.7.4.1.3.1]
b. 2 Jan 1891
10
William Hoyt
[1.12.4.1.5.4.4.7.4.2]
b. 12 Oct 1813
+
Mrs Hoyt
10
Samuel True Hoyt
[1.12.4.1.5.4.4.7.4.3]
b. Abt 1814
10
True Worthy Hoyt
[1.12.4.1.5.4.4.7.4.4]
b. 31 Aug 1815 d. 1900
Phebe Ann Jameson
b. 1820
11
Phoebe Sophronia Hoyt
[1.12.4.1.5.4.4.7.4.4.1]
b. 12 May 1847 d. 4 Aug 1849
11
Sarah Elizabeth Hoyt
[1.12.4.1.5.4.4.7.4.4.2]
b. 16 Aug 1850 d. 22 Jan 1855
11
True Worthy Hoit
[1.12.4.1.5.4.4.7.4.4.3]
b. 15 May 1853
+
Louisa Catherine M. Murenberg
11
Elisabeth Jamison Hoit
[1.12.4.1.5.4.4.7.4.4.4]
b. 16 Jun 1856
+
William H S Thorburn
11
Homer A Hoit
[1.12.4.1.5.4.4.7.4.4.5]
b. 17 Dec 1858 d. 28 Feb 1923
+
Florence E Hickey
11
Fanny Story Hoyt
[1.12.4.1.5.4.4.7.4.4.6]
b. 19 Oct 1861
10
Albert Lewis Hoyt
[1.12.4.1.5.4.4.7.4.5]
b. 23 Dec 1822 d. 10 Aug 1843
8
Asa Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.8]
b. 29 Mar 1764 d. 25 Feb 1829
Irene Carpenter
b. 28 Jan 1766 d. 5 Oct 1846
9
Derick Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.8.1]
b. 22 May 1788 d. Abt 1846
Rachael Roberts
b. 1800 d. Aft 1860
10
Caroline Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.8.1.1]
b. 1833 d. Aft 1860
W L Evans
b. 1827 d. Aft 1860
11
Anna B Evans
[1.12.4.1.5.4.4.8.1.1.1]
b. 1852 d. Aft 1860
9
Sophia Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.8.2]
b. 5 Oct 1790 d. 4 Feb 1841
Oren Hall
b. 1789 d. Dec 1820
10
Sophia Edna Hall
[1.12.4.1.5.4.4.8.2.1]
b. 1 Apr 1809 d. 1870
Edwin Thomson
b. 1808 d. Abt 1857
11
Mortimer Neal Thomson
[1.12.4.1.5.4.4.8.2.1.1]
b. 2 Sep 1831 d. 25 Jun 1875
Anna Houston VanCleve
b. 1840 d. Dec 1858
12
Mark VanCleve Thomson
[1.12.4.1.5.4.4.8.2.1.1.1]
b. 1859
Grace Harrington Eldredge
b. 24 Feb 1841 d. 13 Dec 1862
12
Ethel Thomson
[1.12.4.1.5.4.4.8.2.1.1.2]
b. 1 Dec 1862 d. 1944
11
Clifford Thomson
[1.12.4.1.5.4.4.8.2.1.2]
b. 15 Apr 1834 d. 29 Sep 1912
Sarah Maria Dutton
b. 1844 d. 23 Oct 1934
12
Clifford Thomson
[1.12.4.1.5.4.4.8.2.1.2.1]
b. 1868 d. Bef 1880
12
Florence F Thomson
[1.12.4.1.5.4.4.8.2.1.2.2]
b. 13 Jun 1869 d. 27 Jul 1939
12
Winifred E Thomson
[1.12.4.1.5.4.4.8.2.1.2.3]
b. 22 Feb 1871 d. 26 Jun 1950
10
Edwin Oscar Hall
[1.12.4.1.5.4.4.8.2.2]
b. 21 Oct 1810 d. 19 Sep 1883
Sarah Lyon Williams
b. 27 Oct 1812 d. 15 Aug 1876
11
Sophia Elizabeth Hall
[1.12.4.1.5.4.4.8.2.2.1]
b. 4 Jul 1836 d. 26 May 1863
William White
b. 28 Feb 1837 d. 8 May 1896
12
Lucy Sophia White
[1.12.4.1.5.4.4.8.2.2.1.1]
b. 25 Mar 1861 d. 25 Apr 1891 [
=>
]
12
Edwin Oscar White
[1.12.4.1.5.4.4.8.2.2.1.2]
b. 6 May 1863 d. 9 Jun 1940 [
=>
]
11
Caroline Alice Hall
[1.12.4.1.5.4.4.8.2.2.2]
b. 5 Nov 1839 d. 29 Jan 1868
11
William Wisner Hall
[1.12.4.1.5.4.4.8.2.2.3]
b. 1 Jun 1841 d. 23 May 1910
Elizabeth Archer VanCleve
b. 25 Nov 1846 d. 27 Jun 1918
12
William Sibley Hall
[1.12.4.1.5.4.4.8.2.2.3.1]
b. 30 Jan 1867 d. 19 Oct 1868
12
Horatio VanCleve Hall
[1.12.4.1.5.4.4.8.2.2.3.2]
b. 15 Jan 1871 d. 20 Aug 1889
12
Charlotte VanCleve Hall
[1.12.4.1.5.4.4.8.2.2.3.3]
b. 31 Jul 1876 d. 23 May 1969
12
Theodore Seymour Hall
[1.12.4.1.5.4.4.8.2.2.3.4]
b. 16 Feb 1880 d. 6 Mar 1963 [
=>
]
12
Edwin Oscar Hall
[1.12.4.1.5.4.4.8.2.2.3.5]
b. 30 May 1881 d. 28 Oct 1946 [
=>
]
12
Florence Hall
[1.12.4.1.5.4.4.8.2.2.3.6]
b. 18 May 1884 d. 9 Mar 1982 [
=>
]
12
Philip Cushman Hall
[1.12.4.1.5.4.4.8.2.2.3.7]
b. 11 Dec 1886 d. 28 Apr 1972
11
Cornelia Hall
[1.12.4.1.5.4.4.8.2.2.4]
b. 25 Aug 1842 d. 27 Apr 1911
Peter Cushman Jones
b. 10 Dec 1837 d. 23 Apr 1922
12
Edwin Austin Jones
[1.12.4.1.5.4.4.8.2.2.4.1]
b. 11 May 1863 d. 10 Jul 1898 [
=>
]
12
Ada Jones
[1.12.4.1.5.4.4.8.2.2.4.2]
b. 28 Oct 1869 d. 28 Jun 1950 [
=>
]
12
Alice Hall Jones
[1.12.4.1.5.4.4.8.2.2.4.3]
b. 2 Jan 1880 d. 10 Oct 1974
+
Mary Lyon Dame
b. 6 Oct 1848 d. 16 Mar 1908
10
Asa Sibley Hall
[1.12.4.1.5.4.4.8.2.3]
b. 23 Apr 1818
Joseph Willard Seymour
b. 29 Mar 1781 d. 25 Jan 1867
10
Oren T Seymour
[1.12.4.1.5.4.4.8.2.4]
b. 1824
10
Mary E. Seymour
[1.12.4.1.5.4.4.8.2.5]
b. Abt 1825 d. Aft 1850
10
Theodore S. Seymour
[1.12.4.1.5.4.4.8.2.6]
b. 1 Jul 1828 d. 1902
9
Lucy Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.8.3]
b. 21 Jul 1792 d. 18 Jul 1795
9
Levi Waite Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.8.4]
b. 4 Mar 1801 d. 13 Aug 1844
Nancy Ann Remington
b. 18 Sep 1801 d. 9 Jan 1870
10
Augustus Furburt Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.8.4.1]
b. 15 Jul 1827
Mary Williamsen Ogden
b. 20 May 1838 d. 15 Jan 1890
11
Herman Clark Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.8.4.1.1]
b. 22 Nov 1860
10
Amanda Maria Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.8.4.2]
b. 25 Oct 1829 d. 31 Mar 1861
John Francis Hoyt
b. 18 Oct 1816
11
Harriet M Hoyt
[1.12.4.1.5.4.4.8.4.2.1]
b. 19 Oct 1849
10
William Wisner Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.8.4.3]
b. 4 Feb 1831 d. 30 Jun 1870
+
Helen Jane Wilcox
b. 31 Aug 1831
10
Harriet Remington Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.8.4.4]
b. 12 Jul 1833 d. Aug 1844
10
George Ainsworth Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.8.4.5]
b. 13 Jun 1834 d. 29 Dec 1856
10
Levi Edwin Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.8.4.6]
b. 8 Sep 1839 d. 29 Oct 1900
Sarah Ella Martling
b. Oct 1852 d. 28 Dec 1932
11
Lucy M Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.8.4.6.1]
b. 1876 d. 1888
11
William W Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.8.4.6.2]
b. Dec 1877
Florence Z Parsons
b. 1883
12
Edwin Gerald Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.8.4.6.2.1]
b. 4 Apr 1906 d. Dec 1963
12
Frederick Warren Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.8.4.6.2.2]
b. 1907 d. 1941
12
William Parsons Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.8.4.6.2.3]
b. 1909 d. 1967
12
George E Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.8.4.6.2.4]
b. 1914
11
George Edwin Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.8.4.6.3]
b. 24 Jun 1881
9
Mary Ann Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.8.5]
b. 18 Dec 1804 d. 18 Oct 1870
Edwin Scrantom
b. 9 May 1803 d. 3 Oct 1880
10
Stella Benton Scrantom
[1.12.4.1.5.4.4.8.5.1]
b. 12 Jan 1827
+
Galusha Phillips
b. 27 Apr 1820 d. 1880
10
Adrian George Scrantom
[1.12.4.1.5.4.4.8.5.2]
b. 26 Oct 1828 d. 1880
+
Mary Sheldon
b. Abt 1832
+
Charlotta
d. 1880
+
Helen Jane Wilcox
b. 31 Aug 1831 d. Abt 1900
10
Cora Irene Scrantom
[1.12.4.1.5.4.4.8.5.3]
b. 28 Jun 1830 d. 31 Dec 1858
John E Sabine
b. Abt 1826 d. 7 Jul 1854
11
Cora Lovisa Sabine
[1.12.4.1.5.4.4.8.5.3.1]
b. 30 Jan 1850
11
Mary Irene Sabine
[1.12.4.1.5.4.4.8.5.3.2]
b. 8 Jan 1853
Franklin Earl Childs
b. 16 Oct 1848
12
Emalita Phillips Childs
[1.12.4.1.5.4.4.8.5.3.2.1]
b. 21 Oct 1879
12
Daniel B Childs
[1.12.4.1.5.4.4.8.5.3.2.2]
b. 18 Sep 1881
11
Sibly Phillips Sabine
[1.12.4.1.5.4.4.8.5.3.3]
b. 23 Dec 1854
George Williams
b. 24 Nov 1831 d. 10 Feb 1895
11
Child Williams
[1.12.4.1.5.4.4.8.5.3.4]
b. 31 Dec 1858 d. 31 Dec 1858
10
Edwina Jane Scrantom
[1.12.4.1.5.4.4.8.5.4]
b. 24 Sep 1832 d. Abt 1839
10
Hamlet Edwin Scrantom
[1.12.4.1.5.4.4.8.5.5]
b. Abt 1833 d. Abt 1833
10
Beulah Mary Scrantom
[1.12.4.1.5.4.4.8.5.6]
b. 15 Jan 1835 d. 1 Jan 1900
Isaac H Weaver
b. Abt 1831 d. Bef 1867
11
Edwin James Weaver
[1.12.4.1.5.4.4.8.5.6.1]
b. 1857 d. 12 Aug 1874
Ensley Mills Smith
b. 8 Aug 1828 d. 7 May 1886
11
Emmalita A Smith
[1.12.4.1.5.4.4.8.5.6.2]
b. 12 Apr 1868 d. 29 Sep 1879
11
Mary Elizabeth Smith
[1.12.4.1.5.4.4.8.5.6.3]
b. 6 Jul 1870 d. 13 Oct 1879
11
Ensley Boyd Smith
[1.12.4.1.5.4.4.8.5.6.4]
b. 10 Jan 1876 d. 7 Aug 1956
+
Stella Louisa Jerome
b. 6 May 1876 d. 8 Feb 1955
10
Edwin Levi Scrantom
[1.12.4.1.5.4.4.8.5.7]
b. Abt 1837 d. Abt 1837
10
Clifford Sibley Scrantom
[1.12.4.1.5.4.4.8.5.8]
b. Abt 1841 d. Abt 1844
10
Melford Clark Scrantom
[1.12.4.1.5.4.4.8.5.9]
b. 4 Nov 1844 d. Abt 1845
10
Bertha Sibley Scranton
[1.12.4.1.5.4.4.8.5.10]
b. 29 Nov 1848
9
George Ainsworth Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.8.6]
b. 9 Apr 1809 d. 1 Jun 1836
9
Daughter Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.8.7]
c. 1 Oct 1809 d. 1809
8
Jonathan Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.9]
b. 8 May 1766 d. 20 Feb 1823
Mary Davis
b. 24 Feb 1768 d. 23 Jun 1840
9
Davis Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.9.1]
b. 29 Nov 1788 d. 21 Nov 1828
Cynta Fisher
b. Abt 1797 d. 6 Jul 1874
10
Nelson Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.9.1.1]
b. 4 Mar 1820 d. 10 Mar 1850
10
Franklin Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.9.1.2]
b. 1 Oct 1821 d. 1878
Julia Badger Leavitt
b. 29 Jul 1826 d. 28 Jan 1864
11
Mary Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.9.1.2.1]
b. 1847
11
Frederick M Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.9.1.2.2]
b. Jun 1849 d. 2 Oct 1912
11
Davis Origin Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.9.1.2.3]
b. 28 Jun 1853 d. 22 May 1913
11
George F Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.9.1.2.4]
b. Sep 1853
11
Walter Frank Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.9.1.2.5]
b. Sep 1857 d. 4 Jun 1911
Clara Greenwood Beecher
b. 6 Feb 1857 d. 21 Sep 1949
12
Chester L Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.9.1.2.5.1]
b. 1882 d. 1884
12
Maurice Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.9.1.2.5.2]
b. 1886 d. 1894
12
Frank Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.9.1.2.5.3]
b. 1888 d. 1890
12
Hazel Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.9.1.2.5.4]
b. 27 Jun 1892 d. 10 Feb 1948
12
Gladys L Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.9.1.2.5.5]
b. 1896 d. 1928
11
John L Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.9.1.2.6]
b. 1859
Ellen W Floyd
b. 1836 d. 1 Jul 1878
11
Ernia M Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.9.1.2.7]
b. Jun 1878 d. 12 Jul 1878
11
Ena L Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.9.1.2.8]
b. Jun 1878 d. 30 Jun 1878
10
Laura Messenger Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.9.1.3]
b. 6 Dec 1822 d. 13 Jan 1861
10
Mary Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.9.1.4]
b. 15 Apr 1825 d. 21 Aug 1826
10
Martha Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.9.1.5]
b. 18 Jun 1826 d. Sep 1826
10
Mary Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.9.1.6]
b. 7 Aug 1827 d. 16 Oct 1840
10
Caroline F Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.9.1.7]
b. 14 Dec 1828 d. 7 Apr 1853
+
Cyrus Harris
9
Mary Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.9.2]
b. 13 Apr 1792 d. 9 Nov 1844
Augustine White
b. 19 Jan 1777
10
Mary Ann White
[1.12.4.1.5.4.4.9.2.1]
b. 19 Apr 1812 d. 12 May 1823
10
Eliza Malvina White
[1.12.4.1.5.4.4.9.2.2]
b. 30 Nov 1814 d. 7 Apr 1858
+
Henry W Nichols
10
Cynthia Sibley White
[1.12.4.1.5.4.4.9.2.3]
b. 8 May 1818
10
Augusta Holven White
[1.12.4.1.5.4.4.9.2.4]
b. 28 Jan 1821
+
Daniel Scott
10
Lucy Violy White
[1.12.4.1.5.4.4.9.2.5]
b. 20 Oct 1824 d. Jul 1845
10
John S White
[1.12.4.1.5.4.4.9.2.6]
b. 2 Jul 1827
+
Emilie Jouret
10
Davis J White
[1.12.4.1.5.4.4.9.2.7]
b. 27 Jan 1833
9
Jonathan W Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.9.3]
b. 13 Aug 1800 d. 26 Sep 1829
Brooksey Case
b. 30 Sep 1804 d. 15 Mar 1829
10
Albert C Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.9.3.1]
b. 3 Jun 1828 d. Feb 1852
8
Benjamin Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.10]
b. 29 Apr 1768 d. 2 Oct 1829
Zilpah Davis
b. 13 Apr 1771 d. 16 May 1824
9
Samuel Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.10.1]
b. 30 Nov 1792 d. 4 Mar 1858
Lucinda Holbrock
b. 19 Mar 1806 d. 2 Mar 1830
10
Giles H Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.10.1.1]
b. 26 May 1825 d. 10 Jun 1825
10
Morella Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.10.1.2]
b. 19 Jun 1827 d. 31 Jul 1849
10
Lucinda Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.10.1.3]
b. 12 Jul 1829 d. 4 Sep 1854
Almira Dixon
b. 3 Apr 1807
10
Elizabeth H Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.10.1.4]
b. 20 Nov 1833
+
Joseph Fisk
10
Mary Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.10.1.5]
b. 16 Jan 1838 d. 17 Aug 1839
10
Helen Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.10.1.6]
b. 23 Sep 1842 d. 3 Feb 1844
10
George H Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.10.1.7]
b. 25 Aug 1845
+
Theodocia Townsend
9
Patty Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.10.2]
b. 6 Feb 1799 d. 12 Jul 1805
9
Nancy Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.10.3]
b. 7 Feb 1806 d. 14 Feb 1806
9
Hiram Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.10.4]
b. 6 Feb 1807 d. 12 Jul 1888
Elizabeth Maria Tinker
b. 11 Aug 1815 d. 11 Jul 1903
10
Zilpha Louisa Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.10.4.1]
b. 7 Dec 1833 d. 16 Jun 1868
Hobart Ford Atkinson
b. 5 Oct 1825 d. 14 Aug 1908
11
Marie Louise Atkinson
[1.12.4.1.5.4.4.10.4.1.1]
b. 24 Feb 1864 d. 29 Oct 1940
+
Gilman Henry Hubbell Perkins
b. 2 Nov 1861 d. 12 Mar 1894
+
Ernest Russell Willard
b. 11 Mar 1854 d. 6 May 1937
11
Elizabeth Storer Atkinson
[1.12.4.1.5.4.4.10.4.1.2]
b. Abt 1866 bur. 16 Feb 1945
10
Giles Benjamin Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.10.4.2]
b. 8 Apr 1841 d. 14 Mar 1843
10
Hiram Watson Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.10.4.3]
b. 2 Mar 1845 d. 28 Jun 1932
Margaret Durbin Harper
b. 14 Feb 1852 d. 28 May 1939
11
Margaret Harper Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.10.4.3.1]
b. 14 Dec 1873 d. 30 Nov 1874
11
Hiram Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.10.4.3.2]
b. 24 Jul 1875 d. 12 Apr 1886
11
John Durbin Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.10.4.3.3]
b. 3 Nov 1883 d. 18 Sep 1888
11
Fletcher Harper Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.10.4.3.4]
b. 5 Apr 1885 d. 24 Apr 1959
Georgianna Harding Farr
b. 30 May 1887 d. 10 Jun 1980
12
Jane Harper Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.10.4.3.4.1]
b. 27 Jul 1918 d. 5 Feb 2006
11
Margaret Urling Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.10.4.3.5]
b. 17 Jan 1893 d. 3 Apr 1951
+
O'Donnell Iselin
b. 6 Oct 1884 d. 7 Nov 1971
10
Emily Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.10.4.4]
b. 10 May 1855 d. 8 Feb 1945
Isaac Seymour Averill
b. 21 Jun 1850 d. 25 Oct 1909
11
Elizabeth Louise Averell
[1.12.4.1.5.4.4.10.4.4.1]
b. 25 Jan 1877 d. 2 Apr 1886
11
James G Averell
[1.12.4.1.5.4.4.10.4.4.2]
b. 23 Dec 1877 d. 30 Nov 1904
James Sibley Watson
b. 11 Mar 1860 d. 1951
11
James Sibley "Sibley" Watson, Jr
[1.12.4.1.5.4.4.10.4.4.3]
b. 10 Aug 1894 d. 31 Mar 1982
Hildegarde Lasell
b. 28 Dec 1888 d. 1976
12
Michael Lasell Watson
[1.12.4.1.5.4.4.10.4.4.3.1]
b. 2 Jan 1918 d. 26 Nov 2012
12
Jeanne Iseult Watson
[1.12.4.1.5.4.4.10.4.4.3.2]
b. 14 Dec 1921 d. 9 Mar 1991
8
Soloman Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.11]
b. 17 Nov 1769
Sally Stockwell
b. 21 Jan 1774
9
Stephen Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.11.1]
b. 12 Dec 1792
9
Nancy Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.11.2]
b. 19 Jan 1797
+
Nathan Muzzy
b. 24 Dec 1792 d. 23 Jun 1858
9
Heister Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.11.3]
b. 19 Jun 1799
9
Lewis Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.11.4]
b. 8 Jul 1801
9
Stephen Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.11.5]
b. 26 Jul 1805
Charlotte Reed Peirce
b. 7 Jul 1811 d. 22 Aug 1882
10
John Reed Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.11.5.1]
b. 18 Apr 1838
10
George H Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.11.5.2]
b. 17 Aug 1841
+
Emma J Gould
b. 8 Jul 1850
10
Martha P Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.11.5.3]
b. 16 Nov 1843
10
Mary Charlotte Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.11.5.4]
b. 18 May 1847
Albert Marritt Phillips
b. 9 Oct 1843
11
Clara Willis Phillips
[1.12.4.1.5.4.4.11.5.4.1]
b. 13 May 1884
10
Clara Sophronia Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.11.5.5]
b. 8 Nov 1849
Otis Sumner Pond
b. 3 Nov 1846
11
Arthur N Pond
[1.12.4.1.5.4.4.11.5.5.1]
b. 1 Mar 1873
+
Mary J
b. Jun 1872
11
Herbert Carroll Pond
[1.12.4.1.5.4.4.11.5.5.2]
b. 26 May 1877 d. 7 Dec 1930
Mary Jane Leake
b. 1884 d. 23 May 1970
12
Elsie Clara Margaret Pond
[1.12.4.1.5.4.4.11.5.5.2.1]
b. 21 Nov 1901 d. 6 Sep 1986
12
Adelaide E Pond
[1.12.4.1.5.4.4.11.5.5.2.2]
b. 1903
9
Solomon Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.11.6]
b. 14 Jun 1808
9
John Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.11.7]
b. 20 Feb 1818 d. 17 Aug 1824
8
Polly Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.12]
b. 4 Dec 1771
Abner C Cummings
b. 9 Oct 1770 d. 1800
9
Nancy Cummings
[1.12.4.1.5.4.4.12.1]
b. 5 Nov 1795
John Putnam
b. Abt 1792
10
Dulcina Putnam
[1.12.4.1.5.4.4.12.1.1]
b. 12 Dec 1813 d. 20 Jul 1816
10
Harriet Putnam
[1.12.4.1.5.4.4.12.1.2]
b. 20 Mar 1815 d. 20 Jul 1816
10
Jane Putnam
[1.12.4.1.5.4.4.12.1.3]
b. 1 Nov 1816
Walters Putnam
b. 16 Mar 1817
11
Sarah Jane Putnam
[1.12.4.1.5.4.4.12.1.3.1]
b. 1 Nov 1841
11
Nancy L Putnam
[1.12.4.1.5.4.4.12.1.3.2]
b. 15 Aug 1845
+
James W Davis
11
Marble Putnam
[1.12.4.1.5.4.4.12.1.3.3]
b. 19 Aug 1847
Evaline Inez Waters
b. 10 Sep 1850
12
Justin Marble Putnam
[1.12.4.1.5.4.4.12.1.3.3.1]
b. 27 Feb 1873
12
Julia Rosina Putnam
[1.12.4.1.5.4.4.12.1.3.3.2]
b. 22 Aug 1875 d. Mar 1968 [
=>
]
12
Charles Wesley Putnam
[1.12.4.1.5.4.4.12.1.3.3.3]
b. 9 Mar 1880
12
Jane Waters Putnam
[1.12.4.1.5.4.4.12.1.3.3.4]
b. 1 Sep 1882
11
Martha Waters Putnam
[1.12.4.1.5.4.4.12.1.3.4]
b. 3 Nov 1849 d. 8 Feb 1856
11
Henry Waters Putnam
[1.12.4.1.5.4.4.12.1.3.5]
b. 1 Oct 1855
10
John Perry Putnam
[1.12.4.1.5.4.4.12.1.4]
b. 27 Mar 1818
10
Ira Putnam
[1.12.4.1.5.4.4.12.1.5]
b. 15 Nov 1819 d. 12 May 1821
10
Ephraim Laughton Putnam
[1.12.4.1.5.4.4.12.1.6]
b. 30 Apr 1821 d. 3 Dec 1822
9
Clarissa Cummings
[1.12.4.1.5.4.4.12.2]
b. 18 Apr 1796 d. 1838
Creenfield Pote Merrill
b. 26 Aug 1794 d. 27 Mar 1876
10
Edward Pote Merrill
[1.12.4.1.5.4.4.12.2.1]
b. 22 Oct 1820 d. 1870
+
Olive B Lincoln
b. 1823
10
Elizabeth C Merrill
[1.12.4.1.5.4.4.12.2.2]
b. 26 Feb 1822 d. 16 Dec 1839
10
Greenfield Merrill
[1.12.4.1.5.4.4.12.2.3]
b. 14 Dec 1825
10
Samuel Merrill
[1.12.4.1.5.4.4.12.2.4]
b. 28 Oct 1832 d. 1912
10
Creenfield Merrill
[1.12.4.1.5.4.4.12.2.5]
b. 14 Dec 1834
10
Daniel Cummings Merrill
[1.12.4.1.5.4.4.12.2.6]
b. 20 Mar 1837 d. 1925
+
Mary A Noyes
b. 23 May 1841 d. 28 Feb 1893
8
Artamus Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.13]
b. 9 Jul 1773 d. 10 Aug 1777
8
Nahum Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.14]
b. 11 Sep 1775 d. 12 Sep 1796
8
Sally Sibley
[1.12.4.1.5.4.4.15]
b. 6 Jun 1779 d. 21 Mar 1833
Amasa Cummings
b. 17 Jan 1778 d. 22 Mar 1836
9
Abner Cummings
[1.12.4.1.5.4.4.15.1]
b. 1 Jan 1808
9
Sarah Ann Cummings
[1.12.4.1.5.4.4.15.2]
b. 22 Oct 1812
9
Nahum Sibley Cummings
[1.12.4.1.5.4.4.15.3]
b. 7 Jan 1816
+
Hannah Amidon
b. Abt 1730 d. 5 Jun 1822
6
David Gould
[1.12.4.1.5.5]
b. 21 Apr 1694 d. 21 Apr 1694
6
Ebenezer Gould
[1.12.4.1.5.6]
b. 17 Oct 1696
6
Hannah Gould
[1.12.4.1.5.7]
b. 6 Nov 1698 d. Abt 1758
5
Joshua Rea
[1.12.4.1.6]
b. 6 Aug 1664 d. 1710
Elizabeth Leach
b. Abt 1666 d. Aft 1698
6
Hanna Rea
[1.12.4.1.6.1]
b. Abt 1686 d. 2 Nov 1786
6
Sarah Rea
[1.12.4.1.6.2]
b. 28 Apr 1686 d. 9 Jul 1709
6
Elizabeth Rea
[1.12.4.1.6.3]
b. 13 Aug 1687 d. 14 Dec 1711
6
Kesia Rea
[1.12.4.1.6.4]
b. 1 Sep 1689 d. 14 Jun 1724
6
Joshua Rea
[1.12.4.1.6.5]
b. 16 Oct 1691 d. 13 Jan 1770
6
Lydia Rea
[1.12.4.1.6.6]
b. Mar 1693 d. Aft 1694
5
John Rea
[1.12.4.1.7]
b. 23 May 1666 d. 20 Mar 1731
Ruth Putnam
b. Aug 1673
6
John Rhea
[1.12.4.1.7.1]
b. 21 Jun 1702 d. 1750
5
Hannah Rea
[1.12.4.1.8]
b. 1 Aug 1668
4
Phebe Waters
[1.12.4.2]
b. Abt 1638 d. 16 Apr 1672
Thomas West
c. 16 Oct 1629 d. 27 Dec 1720
5
Joseph West
[1.12.4.2.1]
b. 13 Jul 1663 d. 26 Nov 1739
5
Benjamin West
[1.12.4.2.2]
b. 1 Oct 1665 d. 11 Dec 1733
5
John West
[1.12.4.2.3]
b. 1666 d. 1741
5
Samuel West
[1.12.4.2.4]
b. 23 Mar 1659 d. 1695
Rhoda Meacham
b. 1661 d. Oct 1695
6
Samuel West
[1.12.4.2.4.1]
b. Abt 1685
4
James Waters
[1.12.4.3]
b. Abt 1638 d. 11 Sep 1704
Mary Stallworthy
b. 1642 d. 22 May 1695
5
Mary Waters
[1.12.4.3.1]
b. Abt 7 Feb 1670
5
Elizabeth Waters
[1.12.4.3.2]
b. 23 May 1672
5
Abigail Waters
[1.12.4.3.3]
b. 21 Apr 1677
5
Samuel Waters
[1.12.4.3.4]
b. 22 May 1679 d. 12 Feb 1742
5
Daniel Waters
[1.12.4.3.5]
b. 29 Mar 1682 d. 19 Dec 1704
5
Stallworthie Waters
[1.12.4.3.6]
b. 9 Feb 1685
5
Roger Waters
[1.12.4.3.7]
b. 17 Feb 1687
4
Martha Waters
[1.12.4.4]
c. 27 Sep 1640
4
John Waters
[1.12.4.5]
b. Abt 1654 d. 14 Feb 1706
Sarah Tompkins
b. 1636 d. 1707
5
Richard Waters
[1.12.4.5.1]
b. Jun 1664 d. Feb 1725
5
Nathaniel Waters
[1.12.4.5.2]
b. 6 Dec 1671 d. 1718
5
Samuel Waters
[1.12.4.5.3]
b. 29 Mar 1674 d. 1 May
5
Elizabeth Waters
[1.12.4.5.4]
b. 10 Jan 1677 d. 1724
5
Abigail Waters
[1.12.4.5.5]
b. 6 May 1683
5
Symond Waters
[1.12.4.5.6]
b. 3 Mar 1689
4
Elizabeth Waters
[1.12.4.6]
c. 26 Feb 1642 d. 3 Dec 1664
Edmund Bridges
b. 1612 d. 13 Jan 1685
5
John Bridges
[1.12.4.6.1]
b. 1644
4
Abigail Waters
[1.12.4.7]
c. 18 May 1645 d. Abt 1669
William Punchard
b. 1641 d. 1731
5
Abigail Punchard
[1.12.4.7.1]
b. 3 Sep 1670
5
Mary Punchard
[1.12.4.7.2]
b. 7 Jan 1673 d. 24 Aug 1678
5
Wiliam Punchard
[1.12.4.7.3]
b. Abt 1675 d. 16 Dec 1748
5
John Punchard
[1.12.4.7.4]
b. 2 Apr 1682 d. 10 Dec 1740
5
Sarah Punchard
[1.12.4.7.5]
b. 27 Oct 1685
4
Mary Waters
[1.12.4.8]
b. Abt 1646
Clement English
b. Abt 1640 d. Abt 1682
5
Mary English
[1.12.4.8.1]
b. 18 Feb 1668 d. Sep 1702
5
Elizabeth English
[1.12.4.8.2]
b. 9 Feb 1671
5
Joseph English
[1.12.4.8.3]
b. 12 Mar 1673
5
Benjamin English
[1.12.4.8.4]
b. 19 Oct 1678
5
Abigail English
[1.12.4.8.5]
b. 6 Dec 1680 d. 1697
5
Clement English
[1.12.4.8.6]
b. 7 Mar 1683 d. 7 Mar 1683
+
John Stevens
b. Abt 1640
4
Ezekial Waters
[1.12.4.9]
b. 4 Apr 1647 d. 18 Sep 1675
Mary
b. Abt 1650
5
Daniel Waters
[1.12.4.9.1]
b. 1675
4
Susannah A Waters
[1.12.4.10]
c. 1 Feb 1649 d. 21 Dec 1726
Benedictus Pulsipher
b. 1639 d. 10 Apr 1695
5
Richard Pulsipher
[1.12.4.10.1]
b. 31 Mar 1675 d. 25 Mar 1728
5
William Henry Pulsipher
[1.12.4.10.2]
b. 12 Dec 1676 d. Not Needed
5
Susanah Pulsipher
[1.12.4.10.3]
b. 5 Sep 1678 d. Bef 1689
5
Joseph Pulsipher
[1.12.4.10.4]
b. 13 Nov 1680 d. 12 Apr 1711
5
Benjamin Pulsipher
[1.12.4.10.5]
b. 19 May 1683 d. 13 Aug 1763
5
David Pulsipher
[1.12.4.10.6]
b. 27 Sep 1685 d. 17 Jun 1775
5
Jonathan Pulsipher
[1.12.4.10.7]
b. 25 Sep 1687 d. 13 Apr 1763
5
Elizabeth Pulsipher
[1.12.4.10.8]
b. 4 Dec 1689 d. 1699
5
Joanna Pulsipher
[1.12.4.10.9]
c. 10 May 1691 d. 13 Feb 1766
5
Margaret Pulsipher
[1.12.4.10.10]
b. 14 Feb 1694 d. 11 Mar 1744
4
Hannah Waters
[1.12.4.11]
b. 20 Feb 1652/1653 d. 21 Dec 1726
4
William Waters
[1.12.4.12]
b. 1655 d. Aft 1676
3
Judith Waters
[1.12.5]
c. 24 Jan 1607 d. 12 Aug 1609
3
Elizabeth Waters
[1.12.6]
b. 9 Dec 1610 d. 29 Aug 1663
John Joseph Lawrence
b. 8 Oct 1609 d. 11 Jul 1667
4
John Lawrence
[1.12.6.1]
b. 14 Mar 1635 d. 17 Feb 1712
4
Nathaniel Lawrence
[1.12.6.2]
b. 15 Aug 1639 d. 14 Apr 1724
4
Elizabeth Lawrence
[1.12.6.3]
b. 16 Jul 1640
4
Joseph Lawrence
[1.12.6.4]
b. 30 May 1643 d. Aft 1679
4
Jonathan Lawrence
[1.12.6.5]
b. Apr 1644 d. 6 Apr 1648
2
William Manning
[1.13]
b. Abt 1568 d. Abt 1607