Home Page
|
What's New
|
Photos
|
Histories
|
Headstones
|
Reports
|
Surnames
Search
First Name:
Last Name:
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Suomalainen
Svenska
Joan Payne
Abt 1547 - 1600 (53 years)
Submit Photo / Document
Individual
Descendants
Relationship
Timeline
Submit Photo / Doc
Worksheet
Family
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Joan Payne
[1]
b. Abt 1547 d. 1600
John Scudamore
b. 1543 d. 10 Jan 1570
2
William Scudamore
[1.1]
b. 1564 d. 2 Dec 1598
Margeria Lechmere
b. Abt 1568 d. 6 May 1681
3
William Scudamore
[1.1.1]
b. Abt 1585 d. 1636
3
Walter Scudamore
[1.1.2]
b. 1587 d. 1637
3
Robert Scudamore
[1.1.3]
c. 29 Jul 1590 d. 1685
3
Mary Scudamore
[1.1.4]
b. 1612 d. 6 May 1681
Ensign Thomas French, Jr
b. 27 Nov 1608 d. 8 Aug 1680
4
Mary French
[1.1.4.1]
b. 23 Sep 1632 d. 22 Mar 1683
Robert Smith, Jr
b. Jan 1625 d. 30 Aug 1693
5
Thomas Smith
[1.1.4.1.1]
b. 7 Jul 1654 d. 25 Feb 1725
Martha Knowlton
b. 1654 d. 4 Dec 1728
6
Thomas Smith
[1.1.4.1.1.1]
b. 4 Apr 1683 d. 29 Aug 1729
6
Sarah Smith
[1.1.4.1.1.2]
b. Dec 1685 d. 19 Aug 1704
6
Martha Smith
[1.1.4.1.1.3]
b. Abt 1688 d. Dec 1748
6
John Smith
[1.1.4.1.1.4]
b. 24 Jan 1688 d. 22 Nov 1735
Elizabeth Burnham
7
John Smith
[1.1.4.1.1.4.1]
b. 31 Jul 1715 d. 6 Apr 1714
Eleanor Jewett Smith
b. Abt 1717
8
Samuel Smith
[1.1.4.1.1.4.1.1]
b. Abt 1736 d. Abt 1799
8
Mary Smith
[1.1.4.1.1.4.1.2]
b. 22 Jan 1738 d. 26 Sep 1806
8
Thomas Smith
[1.1.4.1.1.4.1.3]
b. 12 Oct 1741 d. 25 Apr 1794
Phoebe Richardson
b. 5 Dec 1740 d. 19 May 1829
9
Thomas Smith
[1.1.4.1.1.4.1.3.1]
b. 10 Nov 1765 d. 17 May 1837
9
Sylvanus Smith
[1.1.4.1.1.4.1.3.2]
b. 1 Jul 1767 d. 22 Feb 1842
Cylinda Hurd
b. Abt 1769 d. Feb 1842
10
Alvin Smith
[1.1.4.1.1.4.1.3.2.1]
b. 10 Apr 1795
10
Elijah Smith
[1.1.4.1.1.4.1.3.2.2]
b. 5 Dec 1796 d. 11 May 1836
10
Vesta Olive Smith
[1.1.4.1.1.4.1.3.2.3]
b. 1798 d. 6 Jul 1878
10
Electa Smith
[1.1.4.1.1.4.1.3.2.4]
b. 5 Apr 1801 d. 21 Jan 1837
10
Lydia Smith
[1.1.4.1.1.4.1.3.2.5]
b. Abt 1802 d. 28 Apr 1883
10
Eunice Smith
[1.1.4.1.1.4.1.3.2.6]
b. 20 May 1806 d. 22 Apr 1894
10
Emeline Smith
[1.1.4.1.1.4.1.3.2.7]
b. Abt 1809 d. 25 Feb 1847
10
Celesta Caroline Smith
[1.1.4.1.1.4.1.3.2.8]
b. 26 Feb 1811 d. 9 Mar 1885
10
Addison Smith
[1.1.4.1.1.4.1.3.2.9]
b. 5 Aug 1814 d. 31 Jan 1879
10
Moses Smith
[1.1.4.1.1.4.1.3.2.10]
b. 1816
9
Electa Smith
[1.1.4.1.1.4.1.3.3]
b. 15 Mar 1769 d. 30 Mar 1813
8
Aaron Smith
[1.1.4.1.1.4.1.4]
b. Abt 1747
8
Sarah Smith
[1.1.4.1.1.4.1.5]
b. Abt 1749
8
Elisha Smith
[1.1.4.1.1.4.1.6]
b. Abt 1758 d. Aft Nov 1808
7
Benjamin Smith
[1.1.4.1.1.4.2]
b. 5 Mar 1717
7
Susanna Smith
[1.1.4.1.1.4.3]
b. 23 Oct 1722
7
Ruth Smith
[1.1.4.1.1.4.4]
c. 11 Jul 1725 d. 28 Jul 1811
7
Abigail Smith
[1.1.4.1.1.4.5]
b. 28 Mar 1725 d. 21 Jun 1725
7
Ephraim Smith
[1.1.4.1.1.4.6]
b. 28 Mar 1727 d. 15 Jun 1727
7
Esther Smith
[1.1.4.1.1.4.7]
b. 9 Feb 1728
6
Ebenezer Smith
[1.1.4.1.1.5]
b. 31 Jul 1690 d. 25 Feb 1758
6
Ephraim Smith
[1.1.4.1.1.6]
b. 12 Aug 1692 d. 3 Sep 1720
6
Mary Smith
[1.1.4.1.1.7]
b. 10 Sep 1694 d. 25 Aug 1785
6
Abigail Smith
[1.1.4.1.1.8]
b. 1696 d. 1 Feb 1772
5
Mary Smith
[1.1.4.1.2]
b. 20 Oct 1658 d. 10 Dec 1716
John Towne
b. 2 Apr 1658 d. 27 Nov 1740
6
John Towne, Jr
[1.1.4.1.2.1]
b. 25 Nov 1682 d. 29 Sep 1683
6
Israel Towne
[1.1.4.1.2.2]
b. 18 Nov 1684 d. 29 Oct 1771
6
Esther Towne
[1.1.4.1.2.3]
b. 13 Dec 1686 d. Bef Oct 1744
6
Ephraim Towne
[1.1.4.1.2.4]
b. 22 Apr 1688 d. 1779
6
David Towne
[1.1.4.1.2.5]
b. 22 Oct 1693 d. 20 Sep 1781
6
Samuel Towne
[1.1.4.1.2.6]
b. 25 Jan 1695 d. 27 Nov 1760
6
Edmund Towne
[1.1.4.1.2.7]
b. 7 May 1699 d. 27 May 1745
Elizabeth Gould
b. 3 Feb 1703 d. 17 Sep 1742
7
Eliza Goold
[1.1.4.1.2.7.1]
b. 29 Dec 1723
7
Debora Goold
[1.1.4.1.2.7.2]
b. Abt 1724 d. 12 Mar 1812
7
Mehitabel Goold
[1.1.4.1.2.7.3]
b. 10 Nov 1728
7
Edmund Towne
[1.1.4.1.2.7.4]
b. 10 Sep 1733
7
Nathaniel Gould
[1.1.4.1.2.7.5]
b. 17 Nov 1734 d. Dec 1781
7
Zaccheus Town
[1.1.4.1.2.7.6]
b. 20 Feb 1736 d. 1740
7
Bathsheba Towne
[1.1.4.1.2.7.7]
b. 28 Mar 1740 d. 1741
7
Mary Towne
[1.1.4.1.2.7.8]
b. 7 Sep 1742 d. 1742
6
John Town, Jr
[1.1.4.1.2.8]
b. 31 May 1702 d. 1775
5
Phebe Smith
[1.1.4.1.3]
b. 26 Aug 1661 d. 14 Jan 1740
Jacob Towne
b. 13 Feb 1658 d. 1 Oct 1741
6
Joshua Towne
[1.1.4.1.3.1]
b. 13 Nov 1684 d. 11 Jun 1762
6
Abigail Towne
[1.1.4.1.3.2]
b. 2 Oct 1687
6
Catharine Towne
[1.1.4.1.3.3]
b. 2 Jan 1690 d. Abt 1720
6
Jacob Towne
[1.1.4.1.3.4]
b. 1693 d. 27 Sep 1727
6
Ruth Towne
[1.1.4.1.3.5]
b. 25 Mar 1698 d. 1 Aug 1739
6
Stephen Towne
[1.1.4.1.3.6]
b. 2 Nov 1700 d. Abt 1777
6
Jabez Towne
[1.1.4.1.3.7]
b. 15 Jun 1704 d. 1 Apr 1783
6
Elisha Towne
[1.1.4.1.3.8]
b. 25 Oct 1706 d. 1786
Sarah Elizabeth Rhodes
b. 6 May 1712 d. 16 May 1762
7
Sarah Towne
[1.1.4.1.3.8.1]
b. 7 Jan 1738
7
John Sergeant Towne
[1.1.4.1.3.8.2]
b. 22 Sep 1740 d. 8 Mar 1830
Anna Cummings
b. 29 May 1745 d. 1816
8
Asa Towne
[1.1.4.1.3.8.2.1]
b. 14 Nov 1764
8
Sarah Towne
[1.1.4.1.3.8.2.2]
b. 12 Mar 1766
8
Anna Towne
[1.1.4.1.3.8.2.3]
b. 2 Sep 1767 d. 24 Mar 1851
8
Amos Towne
[1.1.4.1.3.8.2.4]
b. 17 Apr 1769 d. 1 Mar 1857
8
John Towne
[1.1.4.1.3.8.2.5]
b. 27 Aug 1771 d. 26 Jan 1830
8
Solomon Towne
[1.1.4.1.3.8.2.6]
b. 10 May 1774 d. 5 Jun 1835
8
Joseph Towne
[1.1.4.1.3.8.2.7]
b. 22 Oct 1777
8
Daniel Towne
[1.1.4.1.3.8.2.8]
b. 30 Sep 1779
8
Samuel Towne
[1.1.4.1.3.8.2.9]
b. 27 Mar 1783 d. 24 Oct 1858
8
Lucy Towne
[1.1.4.1.3.8.2.10]
b. 3 Oct 1785 d. 29 Apr 1820
8
Oliver Towne
[1.1.4.1.3.8.2.11]
b. 24 May 1789
7
Mehetabel Town
[1.1.4.1.3.8.3]
b. 23 Sep 1742
7
Absalom Towne
[1.1.4.1.3.8.4]
b. 24 Sep 1744 d. 14 Nov 1813
7
Bathsheba Towne
[1.1.4.1.3.8.5]
b. 18 Oct 1747 d. 25 Jul 1830
5
Ephraim Smith
[1.1.4.1.4]
b. 29 Oct 1663 d. Abt 1732
Mary Ramsdell
b. 27 Jan 1674
6
Mary Smith
[1.1.4.1.4.1]
b. Aug 1695
6
Elizabeth Smith
[1.1.4.1.4.2]
b. 1 Mar 1696
6
Hannah Smith
[1.1.4.1.4.3]
b. 1 Mar 1696
6
Lydia Smith
[1.1.4.1.4.4]
b. Abt 1699 d. 1747
6
Hephzeba Smith
[1.1.4.1.4.5]
b. 25 Mar 1700
6
John Smith
[1.1.4.1.4.6]
b. 18 Nov 1701 d. 26 May 1729
6
Pricilla Smith
[1.1.4.1.4.7]
b. 14 Aug 1702 d. 2 Jan 1738
6
Ephraim Smith
[1.1.4.1.4.8]
b. Abt 1710
6
Nathan Smith
[1.1.4.1.4.9]
b. 1 Jul 1710 d. Abt 1800
6
Abijah Smith
[1.1.4.1.4.10]
c. 17 Oct 1714 d. 10 Jan 1785
6
Sarah Smith
[1.1.4.1.4.11]
b. 20 Nov 1716
Nathaniel Spofford
b. 1712
7
Apphia Spofford
[1.1.4.1.4.11.1]
b. 12 Jan 1734
7
Jonathan Spofford
[1.1.4.1.4.11.2]
b. 28 May 1740
7
Jerusha Spofford
[1.1.4.1.4.11.3]
b. 17 May 1742 d. 26 Nov 1812
7
Jacob Spofford
[1.1.4.1.4.11.4]
b. 24 Jan 1744
7
Nathanael Spofford
[1.1.4.1.4.11.5]
b. Abt 1747
5
Samuel Smith
[1.1.4.1.5]
b. 26 Jan 1666 d. 12 Jul 1748
Rebecca Curtis
b. 20 Jan 1687 d. 2 Mar 1753
6
Phebe Smith
[1.1.4.1.5.1]
b. 8 Jan 1708 d. 2 Mar 1753
Stephen Averill
b. 1704 d. 1753
7
Phebe Averell
[1.1.4.1.5.1.1]
b. Abt 1734
7
Rebecca Averell
[1.1.4.1.5.1.2]
b. Abt 1736
7
Sarah Averell
[1.1.4.1.5.1.3]
b. Abt 1738
7
Samuel Averell
[1.1.4.1.5.1.4]
b. Abt 1740
6
Mary Smith
[1.1.4.1.5.2]
b. 14 Aug 1711 d. 14 Nov 1785
Amos Towne
b. 2 Jul 1709 d. 14 Feb 1747
7
Samuel Towne
[1.1.4.1.5.2.1]
b. Abt 1735
7
Amos Towne
[1.1.4.1.5.2.2]
b. Oct 1737 d. 8 Sep 1793
7
Daniel Towne
[1.1.4.1.5.2.3]
b. 28 Oct 1739
6
Captain Samuel T Smith
[1.1.4.1.5.3]
b. 26 Jan 1714 d. 14 Nov 1785
Priscilla Gould
b. 4 Aug 1707 d. 25 Sep 1744
7
Priscilla Smith
[1.1.4.1.5.3.1]
b. 26 Dec 1735 d. 7 Dec 1792
Jacob Kimball
b. 5 Mar 1731 d. 8 Nov 1810
8
Benjamin Kimball
[1.1.4.1.5.3.1.1]
b. 23 Jan 1757 d. 19 Aug 1776
8
Mehetiball Kimbal
[1.1.4.1.5.3.1.2]
b. 3 Dec 1758 d. 12 Nov 1790
8
Jacob Kimball
[1.1.4.1.5.3.1.3]
b. 2 Feb 1761 d. 24 Jul 1826
8
Priscilla Kimball
[1.1.4.1.5.3.1.4]
b. 10 Mar 1763 d. 2 Sep 1792
8
Ann Kimball
[1.1.4.1.5.3.1.5]
b. 2 Jun 1765 d. 12 Sep 1789
8
Lucy Kimball
[1.1.4.1.5.3.1.6]
b. 6 Sep 1767 bur. Sep 1790
8
Lydia Kimball
[1.1.4.1.5.3.1.7]
b. 28 Jan 1770 d. 20 Apr 1795
8
David Kimball
[1.1.4.1.5.3.1.8]
b. 26 Apr 1772 d. 20 Nov 1795
8
Samuel Kimball
[1.1.4.1.5.3.1.9]
b. Dec 1774 d. 10 Sep 1775
7
Samuel Smith, III
[1.1.4.1.5.3.2]
b. 28 Oct 1737 d. 14 Nov 1785
Rebecca Lovett
b. 9 Jun 1737 d. Aft 1760
8
Rebekah Smith
[1.1.4.1.5.3.2.1]
b. 29 Jun 1760 d. 15 Apr 1816
8
Lydia Smith
[1.1.4.1.5.3.2.2]
b. 14 Apr 1762 d. 19 Dec 1850
Jacob Wilds
b. Abt 1780 d. 16 Jan 1841
9
Mary Wilds
[1.1.4.1.5.3.2.2.1]
b. Sep 1787 d. 29 Feb 1856
9
Moses Wilds
[1.1.4.1.5.3.2.2.2]
b. 8 Oct 1790 d. 1 Nov 1879
Abigail King
b. 10 Jun 1800 d. 25 Aug 1887
10
Mary Wilds
[1.1.4.1.5.3.2.2.2.1]
b. 14 Feb 1818 d. 21 Apr 1895
Nathan A Smith
b. 12 Feb 1820 d. 11 Apr 1888
11
Lydia Smith
[1.1.4.1.5.3.2.2.2.1.1]
b. 4 Aug 1847 d. 22 Nov 1937
+
George B Holbrook
b. 24 Jun 1855 d. 6 May 1926
11
Carlos William Smith
[1.1.4.1.5.3.2.2.2.1.2]
b. 18 Aug 1852 d. 2 May 1928
+
Sarah Clark
b. Abt 1863 d. 1885/1895
Mertie May Smith Loomis
b. 11 Apr 1861 d. 11 Sep 1925
12
Flora Winifred Smith
[1.1.4.1.5.3.2.2.2.1.2.1]
b. 16 Jan 1897 d. 7 Jul 1966 [
=>
]
12
Monroe William Smith
[1.1.4.1.5.3.2.2.2.1.2.2]
b. 22 Jan 1901 d. 8 Dec 1972 [
=>
]
10
Lydia Wilds
[1.1.4.1.5.3.2.2.2.2]
b. 4 Feb 1820
Thomas Jefferson Dickey
b. 10 Dec 1808 d. 1 Feb 1881
11
Henry Dickey
[1.1.4.1.5.3.2.2.2.2.1]
b. 1842 d. 1913
11
Clara Ellen Dickey
[1.1.4.1.5.3.2.2.2.2.2]
b. 5 Apr 1849 d. 15 Jun 1877
John Sawyer
b. Jul 1836 d. 20 Jul 1913
12
Son Sawyer
[1.1.4.1.5.3.2.2.2.2.2.1]
b. 30 Sep 1867
12
Carrie Ella Sawyer
[1.1.4.1.5.3.2.2.2.2.2.2]
b. 6 Jan 1871 d. 21 Nov 1961
12
Daughter Sawyer
[1.1.4.1.5.3.2.2.2.2.2.3]
b. 25 Jan 1876 d. 24 Mar 1876
11
Thomas Jefferson Dickey, Jr
[1.1.4.1.5.3.2.2.2.2.3]
b. 26 Jan 1850 d. 26 Mar 1865
11
Rose A Dickey
[1.1.4.1.5.3.2.2.2.2.4]
b. 22 Jan 1854 d. 22 Mar 1874
11
Lillian Dickey
[1.1.4.1.5.3.2.2.2.2.5]
b. 29 Sep 1859
10
Mehitable "Hittie" Wilds
[1.1.4.1.5.3.2.2.2.3]
b. 17 Jun 1826 d. 1 Nov 1910
Richard Peckham Church
b. 27 Nov 1819 d. 27 Nov 1897
11
George King Church
[1.1.4.1.5.3.2.2.2.3.1]
b. 1 May 1844 d. 1937
Lydia R Cilley
b. 22 Jul 1842 d. 12 Oct 1908
12
Martha L Church
[1.1.4.1.5.3.2.2.2.3.1.1]
b. 1 Sep 1866
12
Lena May Church
[1.1.4.1.5.3.2.2.2.3.1.2]
b. 7 Nov 1877
11
Lydia Church
[1.1.4.1.5.3.2.2.2.3.2]
b. 1846
11
Flora Church
[1.1.4.1.5.3.2.2.2.3.3]
b. Abt 30 Apr 1856 d. 31 Aug 1859
11
Floran A Church
[1.1.4.1.5.3.2.2.2.3.4]
b. 15 May 1859 d. 14 Dec 1931
Hannah E Smith
b. Mar 1863
12
Hilas Bathelder Church
[1.1.4.1.5.3.2.2.2.3.4.1]
b. 9 Sep 1882
12
Etta Bell Church
[1.1.4.1.5.3.2.2.2.3.4.2]
b. 23 Apr 1886
12
George Elwood Church
[1.1.4.1.5.3.2.2.2.3.4.3]
b. Abt 5 Jun 1888 d. 10 Jul 1889
12
Kenneth Clyde Church
[1.1.4.1.5.3.2.2.2.3.4.4]
b. 9 Jun 1890
10
Sally J Wilds
[1.1.4.1.5.3.2.2.2.4]
b. Abt 1828
Christopher Columbus Payne
b. 28 Sep 1828 d. 1 Dec 1883
11
Wilson A Payne
[1.1.4.1.5.3.2.2.2.4.1]
b. 1851 d. 1926
+
Rhoda E Daya
b. 1847
11
Abbie S Payne
[1.1.4.1.5.3.2.2.2.4.2]
b. 1854
John Flanders
12
John Flanders
[1.1.4.1.5.3.2.2.2.4.2.1]
b. 1878 d. 25 Dec 1949
11
Dwight C Payne
[1.1.4.1.5.3.2.2.2.4.3]
b. May 1868 d. 4 Apr 1870
10
Cynthia C Wilds
[1.1.4.1.5.3.2.2.2.5]
b. 30 Aug 1831 d. 26 May 1930
+
Samuel G Saville
b. 28 Nov 1828 d. 1 Dec 1918
9
Asa Wilds
[1.1.4.1.5.3.2.2.3]
b. Abt 1795 d. Abt 1831
9
Nancy Wilds
[1.1.4.1.5.3.2.2.4]
b. 12 May 1798 d. 4 Dec 1884
9
William Wilds
[1.1.4.1.5.3.2.2.5]
b. 16 Jan 1800 d. 16 Feb 1876
Sarah King
b. 19 Jan 1804 d. 13 Mar 1866
10
Diantha Wilds
[1.1.4.1.5.3.2.2.5.1]
b. 2 Dec 1831
Aaron Bunnell Sargent
b. 7 Jun 1829
11
Mary S Sargent
[1.1.4.1.5.3.2.2.5.1.1]
b. 24 Jun 1852 d. 19 Apr 1902
Azariah Barnes
b. Nov 1841 d. Aft 1880
12
Ethel Rosamond Barnes
[1.1.4.1.5.3.2.2.5.1.1.1]
b. 4 Aug 1873 d. 6 Jun 1947 [
=>
]
12
Katie Alice Barnes
[1.1.4.1.5.3.2.2.5.1.1.2]
b. 12 Sep 1875
12
Wilford A Barnes
[1.1.4.1.5.3.2.2.5.1.1.3]
b. 1881 d. 11 Nov 1900
12
Minnie May Barnes
[1.1.4.1.5.3.2.2.5.1.1.4]
b. 9 Jan 1886 d. 9 Oct 1965 [
=>
]
12
Vernie Mildred Barnes
[1.1.4.1.5.3.2.2.5.1.1.5]
b. 16 Oct 1892
12
Nellie D Barnes
[1.1.4.1.5.3.2.2.5.1.1.6]
b. 28 Oct 1878 d. 26 May 1941 [
=>
]
10
Diana Wilds
[1.1.4.1.5.3.2.2.5.2]
b. 2 Dec 1831
Almon Richardson Thurston
b. Abt 1829
11
Emma Thurston
[1.1.4.1.5.3.2.2.5.2.1]
b. 1858
11
Claira C. Thurston
[1.1.4.1.5.3.2.2.5.2.2]
b. 28 Jun 1859
10
Merrill F Wilds
[1.1.4.1.5.3.2.2.5.3]
b. 23 Dec 1832 d. 27 Jul 1903
Satira Bradford
b. Abt 10 Apr 1842 d. 20 Oct 1897
11
Etta May Wilds
[1.1.4.1.5.3.2.2.5.3.1]
b. 21 Jun 1866 d. 22 Dec 1933
Charles Colburn Lord
b. 29 Aug 1864 d. 20 Dec 1944
12
Ralph Christie Lord
[1.1.4.1.5.3.2.2.5.3.1.1]
b. 19 May 1890 d. 5 Feb 1969
12
Wendell E Lord
[1.1.4.1.5.3.2.2.5.3.1.2]
b. 19 Aug 1894 d. 8 Nov 1918
12
Merle E Lord
[1.1.4.1.5.3.2.2.5.3.1.3]
b. 12 Apr 1900 d. 29 Apr 1900
12
Charles Delwin Lord
[1.1.4.1.5.3.2.2.5.3.1.4]
b. 6 Aug 1902 d. 13 Nov 1997
12
Alice Etta Lord
[1.1.4.1.5.3.2.2.5.3.1.5]
b. 19 Jan 1905 d. 12 May 1998
11
Rosie Emma Wilds
[1.1.4.1.5.3.2.2.5.3.2]
b. 21 Apr 1870 d. 27 Dec 1903
Edward D Cook
b. 1865 d. 1935
12
Nellie Cook
[1.1.4.1.5.3.2.2.5.3.2.1]
b. 14 Sep 1897 d. Jun 1983
12
Helen Almina Cook
[1.1.4.1.5.3.2.2.5.3.2.2]
b. 30 Oct 1903 d. 18 May 1931
10
Sarah King Wilds
[1.1.4.1.5.3.2.2.5.4]
b. 2 May 1834 d. 29 Jan 1906
Charles Poole
b. Abt 1830 d. 27 Jan 1906
11
Edward C Poole
[1.1.4.1.5.3.2.2.5.4.1]
b. 1 Nov 1854
11
Ada M Poole
[1.1.4.1.5.3.2.2.5.4.2]
b. 9 Nov 1856 d. 18 Jul 1890
+
Martin luther Sanborn
b. 1852
11
Gertrude S Poole
[1.1.4.1.5.3.2.2.5.4.3]
b. 21 Jun 1863
Walter P Bugbee
b. Abt 1860
12
Orpha P Bugbee
[1.1.4.1.5.3.2.2.5.4.3.1]
b. 22 Apr 1884
12
Charles L Bugbee
[1.1.4.1.5.3.2.2.5.4.3.2]
b. 27 Jun 1886
11
William Everett Poole
[1.1.4.1.5.3.2.2.5.4.4]
b. 13 Jun 1867
+
Hattie L Miller
b. 1871
10
Louisa Wilds
[1.1.4.1.5.3.2.2.5.5]
b. 13 Dec 1838 d. 26 Dec 1893
Alexander Franklin Hayward
b. 11 Apr 1836 d. 4 Jul 1911
11
Ernest Franklin Hayward
[1.1.4.1.5.3.2.2.5.5.1]
b. 1 Oct 1874 d. 17 May 1951
Jennie May Taplin
b. 27 May 1887 d. 6 Feb 1972
12
Vernon Edward Hayward
[1.1.4.1.5.3.2.2.5.5.1.1]
b. 26 Jan 1908 d. 20 Oct 1978
12
Merlin Franklin Hayward
[1.1.4.1.5.3.2.2.5.5.1.2]
b. 17 Mar 1909 d. 3 Dec 1974 [
=>
]
10
Almira Elizabeth Wilds
[1.1.4.1.5.3.2.2.5.6]
b. 11 Sep 1840 d. 21 Feb 1906
Charles Howard Beede
b. 3 Aug 1839 d. 4 Apr 1911
11
Clinton Horatio Beede
[1.1.4.1.5.3.2.2.5.6.1]
b. 11 Jan 1865 d. 19 Mar 1942
+
Besse Viola Jefferds
b. 24 Sep 1880 d. 30 Jan 1964
Ethel Winifred Ladd
b. 6 Sep 1877 d. 7 May 1920
12
Kenneth Charles Beede
[1.1.4.1.5.3.2.2.5.6.1.1]
b. 22 Nov 1898 d. 5 Mar 1961
12
Inez Winifred Beede
[1.1.4.1.5.3.2.2.5.6.1.2]
b. 7 Feb 1900 d. 29 Dec 1978
12
Velma Ladd Beede
[1.1.4.1.5.3.2.2.5.6.1.3]
b. 30 Jan 1903 d. 1984
11
Caroline Adell Beede
[1.1.4.1.5.3.2.2.5.6.2]
b. 28 Apr 1868 d. 12 Sep 1934
Charles N Wales
b. 1864
12
Almira Wales
[1.1.4.1.5.3.2.2.5.6.2.1]
b. Abt 1890
12
Eva May Wales
[1.1.4.1.5.3.2.2.5.6.2.2]
b. Nov 1891
+
Lester Sanborn
b. Abt 1864
11
Rose Emma Beede
[1.1.4.1.5.3.2.2.5.6.3]
b. 1 Nov 1871 d. 17 Nov 1919
Frank Matthew Allen
b. 1865 d. 17 Nov 1919
12
Florence Allen
[1.1.4.1.5.3.2.2.5.6.3.1]
b. 20 Jun 1893
12
Russell Allen
[1.1.4.1.5.3.2.2.5.6.3.2]
b. 5 Jan 1897
12
Sheldon Chancey Allen
[1.1.4.1.5.3.2.2.5.6.3.3]
b. 23 Dec 1900 d. 4 Jan 1996
11
Bertha Alice Beede
[1.1.4.1.5.3.2.2.5.6.4]
b. 22 Oct 1877 d. 27 May 1932
Chauncy Elmer Bixby
b. 14 Sep 1874
12
Velma Christina Bixby
[1.1.4.1.5.3.2.2.5.6.4.1]
b. 25 Mar 1904 d. 1997
11
Ada May Beede
[1.1.4.1.5.3.2.2.5.6.5]
b. 26 May 1881 d. 13 Aug 1881
10
John K Wilds
[1.1.4.1.5.3.2.2.5.7]
d. 5 Feb 1909
Eunice M Dexter
b. 17 Feb 1831 d. 29 May 1898
11
Elwin Aaron Wilds
[1.1.4.1.5.3.2.2.5.7.1]
b. 9 Dec 1859 d. 2 Jul 1932
Mary Tabitha Courtney
b. 26 Nov 1870 d. 13 Jul 1901
12
Pearl Elisabeth Wilds
[1.1.4.1.5.3.2.2.5.7.1.1]
b. 13 May 1884 d. 16 Feb 1973 [
=>
]
12
Roy Elwin Wilds
[1.1.4.1.5.3.2.2.5.7.1.2]
b. 11 Apr 1892 d. 18 Aug 1975 [
=>
]
12
Ralph Oscar Wilds
[1.1.4.1.5.3.2.2.5.7.1.3]
b. 15 Feb 1898 d. Aft 1984
+
Willie Ann Cline
b. 18 Feb 1863 d. 12 Jan 1931
+
Alice Curtis
b. Abt 1850
9
Susan Wilds
[1.1.4.1.5.3.2.2.6]
b. 16 Mar 1803 d. 18 Jan 1869
8
Susanna Smith
[1.1.4.1.5.3.2.3]
b. 9 Mar 1764 d. 18 Sep 1781
8
Samuel Smith
[1.1.4.1.5.3.2.4]
b. 1 Apr 1766 d. 21 Mar 1811
8
Elizabeth Mary Smith
[1.1.4.1.5.3.2.5]
b. 31 Mar 1768
8
Jacob Smith
[1.1.4.1.5.3.2.6]
b. 24 May 1770
8
Anna Smith
[1.1.4.1.5.3.2.7]
b. 8 Jan 1772
8
Son Smith
[1.1.4.1.5.3.2.8]
b. 13 Apr 1773
8
Benjamin Smith
[1.1.4.1.5.3.2.9]
b. 20 Feb 1776 d. 2 Oct 1778
7
Vashti Smith
[1.1.4.1.5.3.3]
b. 5 Oct 1739 d. Aft 1776
Jacobs Hobbs
b. 16 Jun 1745 d. 20 Jan 1823
8
Jacob Hobbs
[1.1.4.1.5.3.3.1]
b. 21 Feb 1768
8
Abraham Hobbs
[1.1.4.1.5.3.3.2]
b. 16 Dec 1769
8
Samuel Hobbs
[1.1.4.1.5.3.3.3]
b. 21 Feb 1772
8
Vashti Hobbs
[1.1.4.1.5.3.3.4]
b. 2 Feb 1774 d. 14 Feb 1836
8
Abigail Hobbs
[1.1.4.1.5.3.3.5]
b. 10 Aug 1776
Soloman Curtis
b. 10 Jul 1739 d. Apr 1766
8
Solomon Curtis
[1.1.4.1.5.3.3.6]
b. 13 Apr 1766
7
Susannah Smith
[1.1.4.1.5.3.4]
b. 24 Jan 1741 d. 13 May 1766
Isaac Hobbs
b. 20 Apr 1743 d. 3 Jun 1815
8
Sarah Hobbs
[1.1.4.1.5.3.4.1]
b. 16 Nov 1766 d. 27 Jan 1823
8
Susannah Hobbs
[1.1.4.1.5.3.4.2]
b. 16 Nov 1766 d. Abt 1870
8
Priscilla Hobbs
[1.1.4.1.5.3.4.3]
b. 28 May 1769 d. 18 May 1771
8
Isaac Hobbs
[1.1.4.1.5.3.4.4]
b. 19 Aug 1770 d. Abt 1870
8
Elizabeth Hobbs
[1.1.4.1.5.3.4.5]
b. 16 Jan 1773 d. 14 Nov 1850
8
Munson Hobbs
[1.1.4.1.5.3.4.6]
b. 5 Mar 1775 d. Abt 1870
8
Samuel Hobbs
[1.1.4.1.5.3.4.7]
b. 1 Dec 1776 d. Abt 1870
8
Humphrey Hobbs
[1.1.4.1.5.3.4.8]
b. 5 Sep 1779 d. Abt 1870
8
Solomon Hobbs
[1.1.4.1.5.3.4.9]
b. 1782 d. 2 May 1854
7
Asael Smith
[1.1.4.1.5.3.5]
b. 7 Mar 1744 d. 31 Oct 1830
Mary Elizabeth Duty
b. 11 Oct 1743 d. 27 May 1836
8
Jesse Smith
[1.1.4.1.5.3.5.1]
b. 20 Apr 1768 d. 16 Mar 1793
Hannah Peabody
b. 1771 d. 28 Sep 1849
9
Benjamin Peabody Smith
[1.1.4.1.5.3.5.1.1]
b. 2 May 1793 d. 15 Jan 1850
Lois Crandall
b. 3 Nov 1799 d. 10 Mar 1882
10
Esther Ann Smith
[1.1.4.1.5.3.5.1.1.1]
b. 15 Oct 1823 d. 24 Dec 1900
10
Martha Wallace Smith
[1.1.4.1.5.3.5.1.1.2]
b. 14 Oct 1825 d. 22 May 1849
10
Edwin Wallace Smith
[1.1.4.1.5.3.5.1.1.3]
b. 13 Apr 1827 d. 1 Sep 1907
10
Henry Storrs Smith
[1.1.4.1.5.3.5.1.1.4]
b. 11 Mar 1829 d. 3 Dec 1852
10
Benjamin Smith
[1.1.4.1.5.3.5.1.1.5]
b. 28 Apr 1833 d. 28 May 1833
10
Peabody Smith
[1.1.4.1.5.3.5.1.1.6]
b. 28 Apr 1833 d. 28 May 1833
10
Adeline Smith
[1.1.4.1.5.3.5.1.1.7]
b. 6 May 1834 d. 20 Aug 1911
10
James Smith
[1.1.4.1.5.3.5.1.1.8]
b. 16 Mar 1836 d. 21 Jan 1840
10
Jane Smith
[1.1.4.1.5.3.5.1.1.9]
b. 16 Mar 1836 d. 18 May 1917
10
Lois Ann Smith
[1.1.4.1.5.3.5.1.1.10]
b. 6 Apr 1838 d. 10 Aug 1922
10
Adelia Clarissa Smith
[1.1.4.1.5.3.5.1.1.11]
b. 12 Jul 1841 d. 6 Apr 1908
9
Eliza Smith
[1.1.4.1.5.3.5.1.2]
b. 9 Mar 1795 d. 22 Jul 1870
Stoddard Hunt
b. 14 Feb 1780 d. 10 Dec 1855
10
Daniel Smith Hunt
[1.1.4.1.5.3.5.1.2.1]
b. 10 Dec 1826 d. 19 Feb 1882
10
Esther Hunt
[1.1.4.1.5.3.5.1.2.2]
b. 10 Apr 1828 d. 1915
10
Fanny Hunt
[1.1.4.1.5.3.5.1.2.3]
b. 8 Sep 1829 d. 30 May 1852
10
Jesse Hunt
[1.1.4.1.5.3.5.1.2.4]
b. 7 Apr 1831 d. 17 Apr 1871
10
Stephen Hunt
[1.1.4.1.5.3.5.1.2.5]
b. 16 Nov 1833 d. 16 Nov 1922
10
Royal Hunt
[1.1.4.1.5.3.5.1.2.6]
b. 22 May 1836 d. 23 Dec 1880
10
Eliza Hunt
[1.1.4.1.5.3.5.1.2.7]
b. 1 Aug 1840 d. 27 Nov 1918
9
Ira Smith
[1.1.4.1.5.3.5.1.3]
b. 30 Jan 1797 d. 5 Mar 1874
Lucy Post
10
Harry Smith
[1.1.4.1.5.3.5.1.3.1]
b. 26 Jul 1824 d. 4 Apr 1906
10
Norman E. Smith
[1.1.4.1.5.3.5.1.3.2]
b. 24 Nov 1825 d. 19 May 1918
10
James M. Smith
[1.1.4.1.5.3.5.1.3.3]
b. 2 Aug 1827 d. 21 Oct 1902
10
Esther Harmon Smith
[1.1.4.1.5.3.5.1.3.4]
b. 19 Feb 1831 d. 24 Dec 1917
10
Hannah P. Smith
[1.1.4.1.5.3.5.1.3.5]
b. 25 Sep 1832 d. 7 Mar 1859
10
Eliza Smith
[1.1.4.1.5.3.5.1.3.6]
b. 27 Jun 1834 d. 15 Dec 1907
10
Jesse Smith
[1.1.4.1.5.3.5.1.3.7]
b. 30 Dec 1837 d. 31 Dec 1917
9
Harvey Smith
[1.1.4.1.5.3.5.1.4]
b. 1 Apr 1799 d. 20 Feb 1872
Betsey M Yurann
b. 1 Jan 1800 d. 12 Jan 1839
10
Charles Chandler Smith
[1.1.4.1.5.3.5.1.4.1]
b. 13 Feb 1827 d. 14 Feb 1870
10
Horace Buck Smith
[1.1.4.1.5.3.5.1.4.2]
b. 24 Aug 1828 d. 10 Jan 1904
10
Elizabeth Smith
[1.1.4.1.5.3.5.1.4.3]
b. 1829
10
Lucy E. Smith
[1.1.4.1.5.3.5.1.4.4]
b. 7 Apr 1830 d. 4 Apr 1842
10
Betsey M. Smith
[1.1.4.1.5.3.5.1.4.5]
b. 7 May 1832 d. 8 May 1832
10
James Renwick Smith
[1.1.4.1.5.3.5.1.4.6]
b. 5 Sep 1833 d. 4 Apr 1842
10
Jason Smith
[1.1.4.1.5.3.5.1.4.7]
b. 27 Jul 1835 d. 23 Mar 1881
10
William N Smith
[1.1.4.1.5.3.5.1.4.8]
b. 22 Oct 1838 d. 6 May 1911
Electa Jenne
b. 25 Nov 1822 d. 17 Nov 1870
10
Benjamin C
[1.1.4.1.5.3.5.1.4.9]
b. 24 Jul 1854 d. 2 May 1872
10
Jane
[1.1.4.1.5.3.5.1.4.10]
b. 30 Sep 1855 d. 18 Oct 1918
10
Friend Smith
[1.1.4.1.5.3.5.1.4.11]
b. 19 Aug 1858 d. 8 Feb 1936
10
Miranda Smith
[1.1.4.1.5.3.5.1.4.12]
b. 15 Feb 1860 d. 26 May 1934
10
King E. Smith
[1.1.4.1.5.3.5.1.4.13]
b. 19 Mar 1862 d. 12 Jun 1865
9
Harriet Tupper Smith
[1.1.4.1.5.3.5.1.5]
b. 8 Apr 1801 d. Apr 1879
+
Ezra Martindall
9
Stephen Smith
[1.1.4.1.5.3.5.1.6]
b. 2 May 1803 d. 16 Apr 1851
+
Hannah Miller Hunt
b. Abt 1805
9
Mary Polly Smith
[1.1.4.1.5.3.5.1.7]
b. 4 May 1805 d. 13 Jun 1870
+
Hiram Chapman
b. 8 Apr 1795 d. 1867
9
Catherine Smith
[1.1.4.1.5.3.5.1.8]
b. 13 Jul 1807 d. 2 May 1888
James Kelsey
b. 9 Jun 1801 d. 9 Sep 1883
10
Hannah Kelsey
[1.1.4.1.5.3.5.1.8.1]
b. 2 Mar 1829 d. 20 Nov 1905
10
Amanda Kelsey
[1.1.4.1.5.3.5.1.8.2]
b. 24 Oct 1830 d. 1 Jun 1914
10
Eleanor Amelia Kelsey
[1.1.4.1.5.3.5.1.8.3]
b. 5 Jul 1832 d. 9 Sep 1900
10
James Edwin Kelsey
[1.1.4.1.5.3.5.1.8.4]
b. 5 Jul 1832 d. 27 Oct 1910
10
Julius Marcellus Kelsey
[1.1.4.1.5.3.5.1.8.5]
b. 21 Jul 1836 d. 3 Nov 1905
10
Royal Smith Kelsey
[1.1.4.1.5.3.5.1.8.6]
b. 7 Jun 1839 d. 24 Sep 1865
10
Mark Kelsey
[1.1.4.1.5.3.5.1.8.7]
b. 8 Aug 1843 d. 26 Nov 1877
9
Royal Smith
[1.1.4.1.5.3.5.1.9]
b. 2 Jul 1809 d. 1882
+
Happeelona Peck
9
Sarah B Smith
[1.1.4.1.5.3.5.1.10]
b. 16 Dec 1810 d. 2 Oct 1887
+
Henry Barnard
+
Christene Smith
8
Priscilla Smith
[1.1.4.1.5.3.5.2]
b. 21 Oct 1769 d. 17 Apr 1860
John Curtis Waller
9
Calvin C. Waller
[1.1.4.1.5.3.5.2.1]
b. 6 Jun 1797 d. Jun 1864
9
Dolly Waller
[1.1.4.1.5.3.5.2.2]
b. 16 Oct 1799 d. 20 Jun 1800
9
Marshall Waller
[1.1.4.1.5.3.5.2.3]
b. 18 Mar 1801
9
Royal H Waller
[1.1.4.1.5.3.5.2.4]
b. 29 Nov 1802 d. 29 Sep 1866
9
Dudley C Waller
[1.1.4.1.5.3.5.2.5]
b. 29 Sep 1804 d. Abt 1868
+
Mrs Dudley C Waller
b. Abt 1806
9
Bushrod W Waller
[1.1.4.1.5.3.5.2.6]
b. 18 Oct 1806
9
Silas Waller
[1.1.4.1.5.3.5.2.7]
b. 1 Jan 1809 d. 2 Jun 1866
Marietta Smith
b. 1811
10
Francis Waller
[1.1.4.1.5.3.5.2.7.1]
b. 9 Feb 1841 d. 27 Oct 1844
10
Ellen Waller
[1.1.4.1.5.3.5.2.7.2]
b. 11 Sep 1845
10
Anna Buffington
[1.1.4.1.5.3.5.2.7.3]
b. 17 Dec 1848 d. 22 Jan 1852
10
Lilla Waller
[1.1.4.1.5.3.5.2.7.4]
b. 21 Dec 1851 d. 20 Jan 1929
9
Salley P Waller
[1.1.4.1.5.3.5.2.8]
b. 31 Oct 1810 d. 15 Aug 1874
9
John J Waller
[1.1.4.1.5.3.5.2.9]
b. 9 Sep 1812 d. 5 Nov 1812
+
Michael Smith
8
Joseph Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3]
b. 12 Jul 1771 d. 14 Sep 1840
Lucy Mack
b. 8 Jul 1775 d. 14 May 1856
9
Son Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.1]
b. 1797 d. 1797
9
Daughter Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.2]
b. 1797 d. 1797
9
Alvin Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.3]
b. 11 Feb 1798 d. 19 Nov 1823
9
Hyrum Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4]
b. 9 Feb 1800 d. 27 Jun 1844
Jerusha Barden
b. 15 Feb 1805 d. 13 Oct 1837
10
Lovina Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.1]
b. 16 Sep 1827 d. 8 Oct 1876
10
Mary Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.2]
b. 27 Jun 1829 d. 29 May 1832
10
John Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.3]
b. 22 Sep 1832
10
Hyrum Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.4]
b. 27 Apr 1834 d. 21 Sep 1841
10
Jerusha Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.5]
b. 13 Jan 1836 d. 27 Jun 1912
10
Sarah Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.6]
b. 2 Oct 1837 d. 6 Nov 1876
Mary Fielding
b. 21 Jul 1801 d. 21 Sep 1852
10
Joseph Fielding Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7]
b. 13 Nov 1838 d. 19 Nov 1918
+
Levira Annette Clark Smith
b. 29 Apr 1842 d. 18 Dec 1888
Julina Lambson
b. 18 Jun 1849 d. 10 Jan 1936
11
Edward Aurthur Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.1]
b. 1 Nov 1858 d. 17 Jul 1911
11
Mercy Josephine Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.2]
b. 14 Aug 1867 d. 6 Jun 1870
11
Mary Sophronia Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.3]
b. 7 Oct 1869 d. 5 Jan 1948
11
Donnette Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.4]
b. 17 Sep 1872 d. 16 Sep 1961
11
Joseph Fielding Smith, Jr
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.5]
b. 19 Jul 1876 d. 2 Jul 1972
Emily Louie Shurtliff
b. 16 Jun 1876 d. 30 Mar 1908
12
Josephine Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.5.1]
b. 18 Sep 1902 d. 16 Sep 1995
12
Julina Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.5.2]
b. 5 Feb 1906 d. 9 May 1997
Ethel Georgina Reynolds
b. 23 Oct 1889 d. 26 Aug 1937
12
Emily Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.5.3]
b. 9 Aug 1909 d. 21 Aug 1994
12
Naomi Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.5.4]
b. 16 Nov 1910 d. 15 Oct 1979
12
Lois Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.5.5]
b. 26 Mar 1912 d. 23 Jan 1981
12
Joseph Fielding Smith, Jr
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.5.6]
b. 18 Dec 1913 d. 23 Aug 1974
12
Amelia Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.5.7]
b. 21 Jun 1916 d. 22 Sep 2005 [
=>
]
12
Lewis Warren Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.5.8]
b. 10 Mar 1918 d. 12 Dec 1944
12
George Reynolds Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.5.9]
b. 13 Feb 1921 d. 28 Oct 1982
12
Living
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.5.10]
12
Living
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.5.11]
+
Jessie Ella Evans
b. 29 Dec 1902 d. 3 Aug 1971
11
David Asael Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.6]
b. 24 May 1879 bur. 9 Apr 1952
11
George Carlos Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.7]
b. 14 Oct 1881 d. 25 Feb 1931
11
Julina Clarissa Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.8]
b. 10 Feb 1884 d. 1 Aug 1923
11
Elias Wesley Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.9]
b. 21 Apr 1886 d. 28 Dec 1970
11
Emily Jane Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.10]
b. 11 Sep 1888 d. 12 Dec 1982
11
Rachel Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.11]
b. 11 Dec 1890 d. 14 Dec 1986
11
Edith Eleanor Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.12]
b. 3 Jan 1894 d. 21 May 1987
11
Marjorie Virginia Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.13]
b. 7 Dec 1906 d. 17 Nov 1994
Sarah Ellen Richards
b. 25 Aug 1850 d. 22 Mar 1915
11
Sarah Ellen Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.14]
b. 5 Feb 1869 d. 11 Feb 1869
11
Leonora Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.15]
b. 30 Jan 1871 bur. 26 Dec 1907
11
Joseph Richards Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.16]
b. 22 Feb 1873 d. 2 Oct 1954
11
Heber John Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.17]
b. 3 Jul 1876 d. 3 Mar 1877
11
Rhoda Ann Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.18]
b. 20 Jul 1878 d. 6 Jul 1879
11
Minerva Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.19]
b. 30 Apr 1880 d. 24 Jan 1958
11
Alice Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.20]
b. 27 Jul 1882 d. 29 Apr 1901
11
Willard Richards Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.21]
b. 20 Nov 1884 d. 11 Sep 1972
Florence Grant
b. 7 Feb 1883 d. 6 Mar 1977
12
Willard Grant Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.21.1]
b. 12 May 1911 d. 16 Dec 1996
12
Florence Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.21.2]
b. 7 Apr 1913 d. 5 Mar 2017
12
Richards Grant Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.21.3]
b. 10 Mar 1915 d. 6 Mar 2000
12
Briant Grant Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.21.4]
b. 15 Dec 1916 d. 6 Jan 2006
12
Heber Joseph Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.21.5]
b. 23 Dec 1918 d. 26 Nov 1943
12
Howard Grant Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.21.6]
b. 13 Mar 1921 d. 28 May 2010
12
Sarah Ellen Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.21.7]
b. 5 May 1923 d. 23 Oct 1980 [
=>
]
12
Paul Grant Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.21.8]
b. 19 May 1925 d. 21 Jan 2000
11
Franklin Richards Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.22]
b. 12 May 1888 d. 25 Dec 1967
11
Jeanetta Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.23]
b. 25 Aug 1891 d. 27 Jan 1932
11
Asenath Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.24]
b. 28 Dec 1896 d. 3 Aug 1982
Edna Lambson
b. 3 Mar 1851
11
Hyrum Mack Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.25]
b. 21 Mar 1872 d. 23 Jan 1918
11
Alvin Fielding Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.26]
b. 7 Aug 1874 d. 4 Jan 1948
11
Alfred Jason Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.27]
b. 13 Dec 1876 d. 6 Apr 1878
11
Edna Melissa Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.28]
b. 6 Oct 1879 d. 26 Oct 1958
11
Albert Jesse Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.29]
b. 16 Sep 1881 d. 25 Aug 1883
11
Robert Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.30]
b. 12 Nov 1883 d. 4 Feb 1886
11
Emma Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.31]
b. 21 Aug 1888 d. 29 Dec 1969
11
Zina Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.32]
b. 11 Oct 1890 d. 25 Oct 1915
11
Ruth Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.33]
b. 21 Dec 1893 d. 17 Mar 1898
11
Martha Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.34]
b. 12 May 1897 d. 7 Aug 1977
Alice Ann Kimball
b. 6 Sep 1858 d. 19 Dec 1946
11
Alice May Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.35]
b. 11 Oct 1877 d. 20 Oct 1920
11
Heber Chase Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.36]
b. 19 Nov 1881 d. 29 Dec 1971
11
Charles Coulson Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.37]
b. 19 Nov 1881 d. 21 Apr 1933
11
Lucy Mack Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.38]
b. 14 Apr 1890 d. 24 Nov 1933
11
Andrew Kimball Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.39]
b. 6 Jan 1893 d. 23 Aug 1951
11
Jesse Kimball Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.40]
b. 21 May 1896 d. 21 May 1953
11
Fielding Kimball Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.41]
b. 9 Apr 1900 d. 20 Oct 1974
Mary Taylor Schwartz
b. 30 Apr 1865 d. 5 Dec 1956
11
John Schwartz Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.42]
b. 20 Aug 1888 d. 3 Aug 1889
11
Calvin Schwartz Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.43]
b. 29 May 1890
11
Samuel Schwartz Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.44]
b. 26 Oct 1892 d. 10 May 1983
11
James Schwartz Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.45]
b. 13 Nov 1894 d. 6 Nov 1950
11
Agnes Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.46]
b. 3 Nov 1897 d. 9 Mar 1966
11
Silas Schwartz Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.47]
b. 3 Jan 1900 d. 23 Apr 1983
11
Royal Grant Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.7.48]
b. 21 May 1906 d. 30 May 1971
10
Martha Ann Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.8]
b. 14 May 1841 d. 19 Oct 1923
William Jasper Harris
b. 25 Oct 1836 d. 24 Apr 1909
11
William Jasper Harris, Jr
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.8.1]
b. 4 Aug 1859 d. 23 Aug 1926
11
Joseph Albert Harris
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.8.2]
b. 19 Aug 1861 d. 28 May 1911
11
Hyrum Smith Harris
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.8.3]
b. 15 Aug 1863 d. 24 Feb 1924
11
Mary Emily Harris
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.8.4]
b. 23 Oct 1865 d. 25 Nov 1947
11
Franklin Hill Harris
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.8.5]
b. 11 Sep 1867 d. 5 Feb 1947
11
Lucy Smith Harris
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.8.6]
b. 10 Mar 1870 d. 25 Jul 1903
11
John Fielding Harris
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.8.7]
b. 28 Jun 1872 d. 28 Nov 1946
11
Mercy Ann Harris
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.8.8]
b. 30 Mar 1874 d. 23 Jan 1905
11
Zina Christine Harris
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.8.9]
b. 13 May 1876 d. 16 Mar 1958
11
Martha Artemesia Harris
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.8.10]
b. 27 Jun 1879 d. 12 Aug 1965
11
Sarah Lovina Harris
[1.1.4.1.5.3.5.3.4.8.11]
b. 8 Dec 1882 d. 21 Apr 1961
+
Catherine Phillips
b. 1 Aug 1819 d. 26 Sep 1905
+
Mercy Rachel Fielding
b. 15 Jun 1807 d. 15 Sep 1893
9
Sophronia Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.5]
b. 17 May 1803 d. 28 Oct 1876
Calvin W Stoddard
b. 7 Sep 1801 d. 19 Nov 1836
10
Eunice Stoddard
[1.1.4.1.5.3.5.3.5.1]
b. 22 Mar 1830 d. 24 Jun 1831
10
Mariah Stoddard
[1.1.4.1.5.3.5.3.5.2]
b. 12 Apr 1832 d. 8 Oct 1896
+
William McCleary
b. 9 Oct 1793 d. Jun 1846
9
Samuel Harrison Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.6]
b. 13 Mar 1808 d. 30 Jul 1844
Mary Bailey
b. 20 Dec 1808 d. 25 Jan 1841
10
Susanna Bailey Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.6.1]
b. 27 Oct 1835 d. 14 Dec 1905
10
Mary Bailey Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.6.2]
b. 27 Mar 1837 d. 14 Oct 1916
10
Samuel Harrison Bailey Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.6.3]
b. 1 Aug 1838 d. 12 Jun 1914
10
Lucy Bailey Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.6.4]
b. 6 Jan 1841 d. Jan 1841
Levira Clark
b. 30 Jul 1815 d. 1 Jan 1893
10
Levira Annette Clark Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.6.5]
b. 29 Apr 1842 d. 18 Dec 1888
+
Joseph Fielding Smith
b. 13 Nov 1838 d. 19 Nov 1918
10
Lovisa Clark Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.6.6]
b. 28 Aug 1843 d. Dec 1843
10
Lucy Jane Clark Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.6.7]
b. 20 Aug 1844 d. 1844
9
Ephraim Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.7]
b. 13 Mar 1810 d. 24 Mar 1810
9
William B Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.8]
b. 13 Mar 1811 d. 13 Nov 1893
Carolina Amanda Grant
b. 22 Jan 1814 d. 22 May 1845
10
Mary Jane Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.8.1]
b. 7 Jan 1834 d. 21 Dec 1878
10
Caroline L Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.8.2]
b. Aug 1839 d. 9 Jan 1878
Roxie Ann Grant
b. 16 Mar 1825 d. 30 Mar 1900
10
Thalia Grant Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.8.3]
b. 21 Sep 1848 d. 27 Nov 1924
10
Hyrum Wallace Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.8.4]
b. 17 Aug 1850 d. 27 Jan 1935
Eliza Elise Jane Sanborn
b. 16 Apr 1827 d. 7 Mar 1889
10
William Enoch Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.8.5]
b. 23 Jul 1858 d. 13 Feb 1930
10
Edson Don Carlos Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.8.6]
b. 16 Sep 1862 d. 13 Feb 1939
10
Louise Mae "Loie " Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.8.7]
b. 8 May 1866 d. 10 May 1925
+
Rosella Goyette
b. 16 May 1830 d. 6 Apr 1923
9
Katherine Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.9]
b. 28 Jul 1813 d. 1 Feb 1900
Wilkins Jenkins Salisbury
b. 6 Jan 1809 d. 27 Nov 1853
10
Elizabeth Salisbury
[1.1.4.1.5.3.5.3.9.1]
b. 9 Apr 1832 d. 15 Jul 1832
10
Lucy Salisbury
[1.1.4.1.5.3.5.3.9.2]
b. 3 Oct 1834 d. 18 Oct 1892
10
Reverend Solomon Jenkins Salisbury
[1.1.4.1.5.3.5.3.9.3]
b. 18 Sep 1835 d. 12 Jan 1927
10
Alvin Salisbury
[1.1.4.1.5.3.5.3.9.4]
b. 7 Jun 1838 d. 21 Aug 1880
10
Reverend Don C. Salisbury
[1.1.4.1.5.3.5.3.9.5]
b. 25 Oct 1840 d. 6 Apr 1919
10
Emma C Salisbury
[1.1.4.1.5.3.5.3.9.6]
b. 25 Mar 1844 d. 10 Oct 1846
10
Lorin Ephraim Salisbury
[1.1.4.1.5.3.5.3.9.7]
b. 4 May 1845 d. 18 Nov 1849
10
Frederick Vilian Salisbury
[1.1.4.1.5.3.5.3.9.8]
b. 27 Jan 1850 d. 24 Feb 1934
+
Joseph Younger
b. 1805 d. 1900
9
Don Carlos Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.10]
b. 25 Mar 1816 d. 7 Aug 1841
Agnes Moultin Coolbrith
b. 11 Jul 1811 d. 26 Dec 1876
10
Agnes Charlotte Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.10.1]
b. 7 Aug 1836 d. 31 Jan 1873
10
Sophronia C. Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.10.2]
b. 22 Apr 1838 d. 3 Oct 1843
10
Josephine Donna "Ina Coolbrith" Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.10.3]
b. 10 Mar 1841 d. 29 Feb 1928
Robert Bruce Carsley
b. 6 Jun 1833 d. 14 Aug 1905
11
Son 1 Carsley
[1.1.4.1.5.3.5.3.10.3.1]
b. 1860 d. 1860
11
Son 2 Carsley
[1.1.4.1.5.3.5.3.10.3.2]
b. 1861 d. Bef 1865
9
Lucy Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.11]
b. 18 Jul 1821 d. 9 Dec 1882
Arthur Millikin
b. 9 May 1817 d. 23 Apr 1882
10
Don Carlos Smith Millikin
[1.1.4.1.5.3.5.3.11.1]
b. 13 Oct 1843 d. 26 Nov 1932
10
Sarah M Millikin
[1.1.4.1.5.3.5.3.11.2]
b. 13 Sep 1844 d. 23 Nov 1934
10
George William Dell Millikin
[1.1.4.1.5.3.5.3.11.3]
b. 4 Mar 1848 d. 16 Jan 1913
10
Florence Arabella Millikin
[1.1.4.1.5.3.5.3.11.4]
b. 23 May 1850 d. 21 Oct 1927
10
Julia Amelia Millikin
[1.1.4.1.5.3.5.3.11.5]
b. 17 Jun 1853 d. 7 Jun 1888
10
Frances A. Millikin
[1.1.4.1.5.3.5.3.11.6]
b. 26 Oct 1856 d. 14 Mar 1858
10
Charles Arthur Millikin
[1.1.4.1.5.3.5.3.11.7]
b. 31 Aug 1858 d. 12 May 1884
10
Clara Irene Millikin
[1.1.4.1.5.3.5.3.11.8]
b. 23 Aug 1861 d. 26 Mar 1948
10
Clarence Hyrum Millikin
[1.1.4.1.5.3.5.3.11.9]
b. 26 Mar 1865 d. 5 Apr 1922
9
Joseph Smith, Jr
[1.1.4.1.5.3.5.3.12]
b. 23 Dec 1805 d. 27 Jun 1844
Emma Hale
b. 10 Jul 1804 d. 30 Apr 1879
10
Alvin Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.1]
b. 15 Jun 1828 d. 15 Jun 1828
10
Joseph Murdock Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.2]
b. 30 Apr 1831 d. 29 Mar 1832
10
Julia Murdock Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.3]
b. 30 Apr 1831 d. 12 Sep 1880
+
Elisha Dixon
b. 1827 d. 1850
+
John J Middleton
b. Abt 1827 d. Abt 1869
10
Thaddeus Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.4]
b. 30 Apr 1831 d. 30 Apr 1831
10
Louisa Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.5]
b. 30 Apr 1831 d. 30 Apr 1831
10
Joseph Smith, III
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.6]
b. 6 Nov 1832 d. 10 Dec 1914
Emmeline Griswold
b. 12 Mar 1838 d. 25 Mar 1869
11
Emma Josepha Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.6.1]
b. 28 Jul 1857 d. 30 Nov 1940
Alexander McCallum
b. 4 Apr 1848 d. 8 Oct 1928
12
Joseph Alma McCallum
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.6.1.1]
b. 19 Sep 1878 d. 1967 [
=>
]
12
Arthur Alexander McCallum
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.6.1.2]
b. 2 Jun 1882 d. 27 Mar 1937
12
William James McCallum
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.6.1.3]
b. 1 Aug 1890 d. 10 Oct 1963
12
Oscar MacEo McCallum
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.6.1.4]
b. 12 Jun 1896 d. 20 Feb 1898
11
Evelyn Rebecca Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.6.2]
b. 25 Jan 1859 d. 30 Sep 1859
11
Carrie Lucinda Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.6.3]
b. 15 Sep 1861 d. 27 Apr 1944
Francis Marion Weld
b. 9 Sep 1858 d. 4 Jul 1938
12
Emma Rebecca Weld
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.6.3.1]
b. 3 Jul 1889 d. Abt 1975 [
=>
]
11
Zaide Viola Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.6.4]
b. 25 Apr 1863 d. 8 Jan 1891
Richard Savary Salyards
b. 16 Jun 1857 d. 27 Nov 1944
12
Emma Marie Salyards
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.6.4.1]
b. 8 Aug 1884 d. 16 Sep 1886
12
Zaide Aileen Salyards
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.6.4.2]
b. 11 Jan 1887 d. 27 May 1973
12
Joseph Richard Salyards
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.6.4.3]
b. 18 Aug 1888 [
=>
]
12
Richard Savary Salyards
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.6.4.4]
b. 21 Jun 1890 d. 28 Feb 1988 [
=>
]
11
Joseph Arthur Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.6.5]
b. 12 Aug 1865 d. 12 Mar 1866
Bertha Madison
b. 16 Jul 1843 d. 19 Oct 1896
11
David Carlos Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.6.6]
b. 14 Aug 1870 d. 24 Jan 1886
11
Mary Audentia Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.6.7]
b. 23 Mar 1872 d. 5 May 1963
11
Frederick Madison Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.6.8]
b. 21 Jan 1874 d. 20 Mar 1946
11
Israel Alexander Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.6.9]
b. 2 Feb 1876 d. 14 Jun 1958
11
Kenneth Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.6.10]
b. 6 Oct 1877 d. 6 Oct 1877
11
Bertha Azubah Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.6.11]
b. 15 Oct 1878 d. 14 Oct 1884
11
Hale Washington Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.6.12]
b. 22 Feb 1881 d. 10 Jul 1956
11
Blossom Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.6.13]
b. 1 May 1883 d. 1 May 1883
11
Lucy Yeteve Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.6.14]
b. 11 Dec 1884 d. 4 Aug 1945
Ada Rachel Clark
b. 23 Jul 1871 d. 20 Oct 1915
11
Reginald Archer Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.6.15]
b. 26 Dec 1898 d. 20 Jun 1969
11
William Wallace Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.6.16]
b. 18 Nov 1900 d. 4 Aug 1989
11
Reginald Archer Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.6.17]
b. 8 Jan 1903 d. 28 Sep 1974
10
Frederick Granger Williams Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.7]
b. 20 Jun 1836 d. 13 Apr 1862
Anna Marie Jones
b. 7 Apr 1841 d. 11 Oct 1901
11
Alice Fredericka Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.7.1]
b. 27 Nov 1858 d. 5 Nov 1932
10
Alexander Hale Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8]
b. 2 Jun 1838 d. 12 Aug 1909
Elizabeth Agnes Kendall
b. 16 Jun 1845 d. 7 May 1919
11
Frederick Alexander Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.1]
b. 19 Jan 1862 d. 25 Jun 1954
Mary Angelina Walker
b. 18 Mar 1867 d. 3 Dec 1931
12
Alexander David Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.1.1]
b. 18 Aug 1885 d. 20 Oct 1891
12
Gladys Inez Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.1.2]
b. 17 Dec 1886 d. 17 Jul 1983 [
=>
]
12
Joy May Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.1.3]
b. 13 Jul 1889 d. 29 Jul 1961 [
=>
]
12
Glaud Leslie Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.1.4]
b. 19 Jan 1891 d. 16 Feb 1986 [
=>
]
12
Freda Saloam Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.1.5]
b. 3 Dec 1892 d. 13 Oct 1974
12
Winsome Lavinia Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.1.6]
b. 20 Aug 1896 d. 30 Nov 1986 [
=>
]
12
Frederick Augenstein Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.1.7]
b. 19 Mar 1899 d. Jan 1966
12
Harold Legrand Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.1.8]
b. 12 Jan 1902 d. 19 Jul 1992
+
Margaret Esther Clark
b. 1 Sep 1901 d. 3 Aug 1987
11
Vida Elizabeth Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.2]
b. 16 Jan 1865 d. 3 Jan 1945
Heman Conoman Smith
b. 27 Sep 1850 d. 17 Apr 1919
12
Heman Hale Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.2.1]
b. 28 Apr 1887 d. 11 Mar 1962 [
=>
]
12
Vida Inez Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.2.2]
b. 16 Jan 1889 d. 24 Oct 1964
12
Anna Earlita Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.2.3]
b. 28 Nov 1890 d. 5 Jun 1975 [
=>
]
12
Lois Elizabeth Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.2.4]
b. 3 Nov 1892 d. 27 Mar 1914 [
=>
]
11
Ina Inez Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.3]
b. 22 Nov 1866 d. 18 Aug 1945
Sidney Garden Wright
b. 26 Jul 1869 d. 8 Aug 1936
12
Claud Kendall Wright
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.3.1]
b. 21 Mar 1892 d. 6 Oct 1972 [
=>
]
12
Vida Grace Wright
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.3.2]
b. 22 Apr 1893 d. 11 Jul 1970 [
=>
]
12
Leland Eric Wright
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.3.3]
b. 30 Dec 1895 d. 11 Nov 1977 [
=>
]
12
Mavis Myra Wright
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.3.4]
b. 30 Dec 1897 d. 15 Aug 1960 [
=>
]
12
Warren Alford Wright
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.3.5]
b. 28 Mar 1899 d. 26 Feb 1980 [
=>
]
12
Edgar Milton Wright
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.3.6]
b. 1 May 1901 d. 2 May 1961 [
=>
]
12
Glory Carmen Wright
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.3.7]
b. 14 Aug 1903 d. 4 Nov 1968
12
Byron Granville Wright
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.3.8]
b. 19 Feb 1906 d. 3 Nov 1974 [
=>
]
12
Marian Inez Wright
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.3.9]
b. 17 Nov 1907 d. 28 Jul 1987 [
=>
]
12
Gwen Hero Wright
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.3.10]
b. 23 Oct 1909 d. 28 Jul 1987
11
Emma Belle Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.4]
b. 17 Mar 1869 d. 3 May 1960
William Forrester Kennedy
b. 5 Jun 1863 d. 22 Mar 1938
12
Arthur Frederick Kennedy
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.4.1]
b. 25 May 1889 d. 1 Jul 1889
12
Joseph Douglas Kennedy
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.4.2]
b. 14 Oct 1891 d. 14 Oct 1891
12
Cecile Grace Kennedy
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.4.3]
b. 3 Jun 1894 d. 9 May 1895
12
Roger Alexander Kennedy
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.4.4]
b. 5 Nov 1897 d. 15 Dec 1933 [
=>
]
12
Glenna Marie Kennedy
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.4.5]
b. 3 Nov 1900 d. 30 Jul 1986
11
Don Alvin Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.5]
b. 17 May 1871 d. 8 Sep 1904
Susan Zeanette Pearsall
b. 21 Apr 1873 d. 22 Jun 1957
12
Velora Belle Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.5.1]
b. 13 Dec 1893 d. 28 Dec 1993
12
Carlos McAllister Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.5.2]
b. 22 May 1895 d. Nov 1981 [
=>
]
12
Beatrice Adelle Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.5.3]
b. 19 Aug 1896 d. 21 Jun 1989 [
=>
]
12
LaJune Harriet Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.5.4]
b. 1 Jul 1899 d. 9 Aug 1985
12
Don Marion Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.5.5]
b. 28 Oct 1901 d. 13 Nov 1983 [
=>
]
12
Maxwell Alexis Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.5.6]
b. 13 Apr 1903 d. 17 Feb 1961 [
=>
]
11
Eva Grace Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.6]
b. 1 Mar 1874 d. 26 Mar 1893
Forrest Lamont Madison
b. 1872 d. 18 Mar 1945
12
Lamont Kendall Madison
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.6.1]
b. 17 Mar 1893 d. 3 Apr 1963 [
=>
]
11
Joseph George Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.7]
b. 7 May 1877 d. 27 Dec 1936
Nellie May Daudelin
b. 19 Jun 1879 d. 2 Apr 1935
12
Josephine Alexandria Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.7.1]
b. 20 Nov 1904 d. 6 Aug 1985 [
=>
]
12
Paul Daudelin Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.7.2]
b. 1 Mar 1908 d. Sep 1975
11
Arthur Marion Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.8]
b. 8 Feb 1880 d. 21 Mar 1964
Estella Almira Danielson
b. 7 Mar 1884 d. 23 Jun 1916
12
Verl Marion Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.8.1]
b. 21 Apr 1905 d. 3 Aug 1980
12
Carl K Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.8.2]
b. 5 Mar 1907 d. 1966
12
Alexander Martin Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.8.3]
b. 7 Feb 1909 d. 30 Sep 1982 [
=>
]
12
Kenneth Julian Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.8.4]
b. 7 Mar 1911 d. 16 Jun 1988 [
=>
]
12
Arthur Granger Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.8.5]
b. 18 Mar 1916 d. 17 Mar 2012
Minnie Catherine Smith
b. 20 May 1894 d. 30 Jan 1988
12
Georgia May Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.8.6]
b. 22 Feb 1923 d. Jul 2009 [
=>
]
12
Myrle Lee Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.8.7]
b. 14 Sep 1925 d. 21 Nov 1985
11
Coral Cecil Rebekah Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.9]
b. 29 Oct 1882 d. 17 Aug 1968
Louis Hurst Horner
b. 21 Sep 1878 d. 18 Feb 1970
12
Louis Brainard Horner
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.9.1]
b. 26 Oct 1906 d. 13 Aug 1980
12
Elizabeth Grace Horner
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.9.2]
b. 16 Apr 1910 d. 19 Jul 1991 [
=>
]
12
James Brandon Horner
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.9.3]
b. 5 Jul 1912 d. 23 Jan 1975
12
Ina Lorena Horner
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.8.9.4]
b. 30 Aug 1915 d. 1 Dec 2004 [
=>
]
10
Don Carlos Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.9]
b. 13 Jun 1840 d. 15 Sep 1841
10
Thomas Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.10]
b. 6 Feb 1842 d. 6 Feb 1842
10
David Hyrum Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.11]
b. 17 Nov 1844 d. 29 Aug 1904
Clara Charlotte Hartshorn
b. 18 May 1851 d. 9 Aug 1926
11
Elbert Aoriul Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.11.1]
b. 8 Mar 1871 d. 15 May 1959
Clara Abigale Cochran
b. 12 Jan 1874 d. 30 Oct 1948
12
Lawrence David Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.11.1.1]
b. 3 Jun 1896 d. 17 Jun 1896
12
Ronald Gibson Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.11.1.2]
b. 10 Oct 1902 d. 4 Feb 1988
12
Lynn Elbert Smith
[1.1.4.1.5.3.5.3.12.11.1.3]
b. 20 Jan 1911 d. 1 Jun 1992 [
=>
]
+
Agnes Moultin Coolbrith
b. 11 Jul 1811 d. 26 Dec 1876
+
Fanny Young
b. 8 Nov 1787 d. 11 Jun 1859
+
Eliza Roxey Snow
b. 21 Jan 1804 d. 5 Dec 1887
+
Francis Ward "Fanny" Alger
b. 30 Sep 1817 d. 29 Nov 1889
+
Louisa Beaman
b. 7 Feb 1815 d. 15 May 1850
+
Helen Mar Kimball
b. 25 Aug 1828 bur. 15 Nov 1896
+
Emily Dow Partridge
b. 28 Feb 1824 d. 9 Dec 1899
+
Olive Grey Frost
b. 24 Jul 1816 d. 8 Oct 1845
+
Rhoda Richards
b. 8 Aug 1784 d. 17 Jan 1879
+
Lucy Walker
b. 30 Apr 1826 d. 1 Oct 1910
+
Sarah Ann Whitney
b. 22 Mar 1825 d. 4 Sep 1873
+
Prescinda Lothrop Huntington
b. 7 Sep 1810 d. 1 Feb 1892
+
Eliza Partridge
b. 20 Apr 1820 bur. 2 Mar 1886
+
Desdemona Wadsworth Fullmer
b. 6 Oct 1809 d. 9 Feb 1886
+
Zina Diantha Huntington
b. 31 Jan 1821 d. 28 Aug 1901
+
Mary Elizabeth Rollins
b. 9 Apr 1818 d. 17 Dec 1913
+
Martha McBride
b. 17 Mar 1805 d. 20 Nov 1901
+
Sylvia Porter Sessions
b. 31 Jul 1818 d. 12 Apr 1882
+
Patty Bartlett
b. 4 Feb 1795 d. 14 Dec 1892
+
Maria Lawrence
b. 18 Dec 1823 d. 1847
+
Sarah A Lawrence
b. 13 May 1826 d. 28 Nov 1872
8
Asahel Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4]
b. 21 May 1773 d. 21 Jul 1848
Elizabeth Shellenger
b. 1 Dec 1785 d. 14 Oct 1846
9
Elias Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.1]
b. 6 Sep 1804 d. 24 Jun 1888
Amy Jane King
b. 2 Oct 1836 d. 8 Nov 1913
10
Silas Thomas Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.1.1]
b. 4 May 1857 d. 1 May 1945
10
Jesse Moroni Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.1.2]
b. 21 Nov 1858 d. 14 Mar 1937
+
Sarah Ann Smith
b. 11 Jul 1868 d. 2 Feb 1900
10
Rebecca Jane Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.1.3]
b. 23 Sep 1860 d. 18 Jul 1923
10
Mary Alzina Knapp Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.1.4]
b. 16 May 1865 d. 20 Jan 1953
10
Martha Priscilla Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.1.5]
b. 30 May 1865 d. 18 Apr 1946
10
Amy Esther Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.1.6]
b. 11 Aug 1867 d. 21 Sep 1910
10
Angelina Adelia Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.1.7]
b. 11 Jul 1869 d. 8 Mar 1950
10
Franklin Elias Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.1.8]
b. 13 Dec 1871 d. 24 Jul 1917
10
Sarah Susannah Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.1.9]
b. 26 Mar 1873 d. 25 Apr 1952
10
Hiram Bennett Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.1.10]
b. 2 Feb 1877 d. 29 Mar 1951
Lucy Brown
b. 4 Jan 1821 d. 3 Apr 1896
10
Emily Jane Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.1.11]
b. 28 Oct 1850 d. 8 May 1878
Wilford Woodruff, Jr
b. 22 Mar 1840 d. 6 May 1921
11
Lucy Emily Woodruff
[1.1.4.1.5.3.5.4.1.11.1]
b. 10 Jan 1869 d. 5 Nov 1937
George Albert Smith
b. 4 Apr 1870 d. 4 Apr 1951
12
Emily Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.1.11.1.1]
b. 20 Nov 1895 d. 28 Feb 1973
12
Edith Elliott
[1.1.4.1.5.3.5.4.1.11.1.2]
b. 10 Nov 1899 d. 13 Jun 1977
12
George Albert Smith, Jr
[1.1.4.1.5.3.5.4.1.11.1.3]
b. 10 Sep 1905 d. 11 Oct 1969
11
Wilford Smith Woodruff
[1.1.4.1.5.3.5.4.1.11.2]
b. 25 Sep 1871 d. 26 Nov 1955
11
Elias Smith Woodruff
[1.1.4.1.5.3.5.4.1.11.3]
b. 15 Dec 1873 d. 16 Nov 1941
Nellie Maria Davis
b. 5 Mar 1872 d. 14 Oct 1960
12
Nettie Woodruff
[1.1.4.1.5.3.5.4.1.11.3.1]
b. 3 Nov 1902 d. 24 Jun 1988
12
Asahel Davis Woodruff
[1.1.4.1.5.3.5.4.1.11.3.2]
b. 21 Oct 1904 d. 20 Jan 1994 [
=>
]
12
Margaret Woodruff
[1.1.4.1.5.3.5.4.1.11.3.3]
b. 30 Sep 1906 d. 6 Mar 1984
12
Elias Laurence Woodruff
[1.1.4.1.5.3.5.4.1.11.3.4]
b. 26 Apr 1908 d. 28 Aug 1909
12
Mildred Jennie Woodruff
[1.1.4.1.5.3.5.4.1.11.3.5]
b. 28 May 1912 d. 6 Mar 1974
11
Asahel Smith Woodruff
[1.1.4.1.5.3.5.4.1.11.4]
b. 30 Mar 1876 d. 7 Oct 1887
10
Lucy Elizabeth Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.1.12]
b. 24 Jan 1855 d. 3 Jun 1944
10
Elias Asahel Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.1.13]
b. 31 Mar 1857 d. 6 Dec 1942
10
Edith Ann Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.1.14]
b. 5 Aug 1861 d. 27 Jun 1954
9
Emily Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.2]
b. 1 Sep 1806 d. 11 Aug 1893
Samuel Pierce Hoyt
b. 21 Nov 1807 d. 12 Aug 1889
10
Cynthia Ann Hoyt
[1.1.4.1.5.3.5.4.2.1]
b. Abt 1848
10
Hyrum Hoyt
[1.1.4.1.5.3.5.4.2.2]
b. 1855
9
Jessie Johnson Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.3]
b. 6 Oct 1808 d. 1 Jul 1834
Sarah Ann Bennett
b. Abt 1808
10
Priscilla Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.3.1]
c. 26 Jul 1840
9
Esther Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.4]
b. 20 Sep 1810 d. 31 Oct 1856
Amos Botsford Fuller
b. 26 Mar 1810 d. 29 Mar 1853
10
Son Fuller
[1.1.4.1.5.3.5.4.4.1]
b. 15 May 1833 d. 15 May 1833
10
Daughter Fuller
[1.1.4.1.5.3.5.4.4.2]
b. 3 Apr 1834 d. 8 Apr 1834
10
Jesse Johnson Fuller
[1.1.4.1.5.3.5.4.4.3]
b. 1 Jun 1835 d. 31 May 1906
10
Mary Adelia Fuller
[1.1.4.1.5.3.5.4.4.4]
b. 31 Aug 1838 d. 5 Jan 1916
10
Luburn Livonia Fuller
[1.1.4.1.5.3.5.4.4.5]
b. 19 Dec 1840 d. 30 Oct 1887
10
Sophina Alcesta Fuller
[1.1.4.1.5.3.5.4.4.6]
b. 5 May 1843 d. 26 Dec 1930
George Washington Gee, Jr
b. 9 Oct 1841 d. 17 Sep 1919
11
George Washington Gee, III
[1.1.4.1.5.3.5.4.4.6.1]
b. 8 May 1864 d. 26 Mar 1865
11
Elias Amos Gee
[1.1.4.1.5.3.5.4.4.6.2]
b. 29 Jun 1868 d. 27 Apr 1936
11
Georgiana Gee
[1.1.4.1.5.3.5.4.4.6.3]
b. 15 Dec 1869 d. 5 Feb 1899
11
Mary Jane Gee
[1.1.4.1.5.3.5.4.4.6.4]
b. 8 Oct 1871 d. 16 May 1916
11
Esther Gee
[1.1.4.1.5.3.5.4.4.6.5]
b. 29 Oct 1875 d. 22 May 1942
11
Sophina Alcesta Gee
[1.1.4.1.5.3.5.4.4.6.6]
b. 6 Aug 1876 d. 17 May 1959
Joshua Robert Hodson
b. 30 Oct 1874 d. 20 Feb 1947
12
Ethelyn Hodson
[1.1.4.1.5.3.5.4.4.6.6.1]
b. 5 Apr 1903 d. 31 May 1999
12
Marva Hodson
[1.1.4.1.5.3.5.4.4.6.6.2]
b. 6 Nov 1905 d. 17 Dec 1992
12
Waldo Gee Hodson
[1.1.4.1.5.3.5.4.4.6.6.3]
b. 12 Jan 1910 d. 1 Apr 2002
12
Afton Hodson
[1.1.4.1.5.3.5.4.4.6.6.4]
b. 2 Jun 1914 d. 3 Dec 1940
12
Robert Gee Hodson
[1.1.4.1.5.3.5.4.4.6.6.5]
b. 6 Dec 1918 d. 2 Mar 1945
11
Don Carlos Gee
[1.1.4.1.5.3.5.4.4.6.7]
b. 20 Apr 1878 d. 11 Jan 1949
11
Bertha Victoria Gee
[1.1.4.1.5.3.5.4.4.6.8]
b. 31 May 1880 d. 27 Dec 1930
11
Martha Electa Gee
[1.1.4.1.5.3.5.4.4.6.9]
b. 28 Apr 1883 d. 13 May 1968
11
Adelia May Gee
[1.1.4.1.5.3.5.4.4.6.10]
b. 14 May 1885 d. 17 Feb 1964
10
Amos Botsford Fuller
[1.1.4.1.5.3.5.4.4.7]
b. 28 Sep 1846 d. 18 Aug 1879
10
Esther Victoria Fuller
[1.1.4.1.5.3.5.4.4.8]
b. 13 Jan 1848 d. 4 Sep 1857
9
Mary Jane Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.5]
b. 29 Apr 1815 d. 1 Mar 1878
George Washington Gee
b. 13 Aug 1815 d. 20 Jan 1842
10
Elias Smith Gee
[1.1.4.1.5.3.5.4.5.1]
b. 30 May 1838 d. 10 Aug 1855
10
George Washington Gee, Jr
[1.1.4.1.5.3.5.4.5.2]
b. 9 Oct 1841 d. 17 Sep 1919
Sophina Alcesta Fuller
b. 5 May 1843 d. 26 Dec 1930
11
George Washington Gee, III
[1.1.4.1.5.3.5.4.5.2.1]
b. 8 May 1864 d. 26 Mar 1865
11
Elias Amos Gee
[1.1.4.1.5.3.5.4.5.2.2]
b. 29 Jun 1868 d. 27 Apr 1936
11
Georgiana Gee
[1.1.4.1.5.3.5.4.5.2.3]
b. 15 Dec 1869 d. 5 Feb 1899
11
Mary Jane Gee
[1.1.4.1.5.3.5.4.5.2.4]
b. 8 Oct 1871 d. 16 May 1916
11
Esther Gee
[1.1.4.1.5.3.5.4.5.2.5]
b. 29 Oct 1875 d. 22 May 1942
11
Sophina Alcesta Gee
[1.1.4.1.5.3.5.4.5.2.6]
b. 6 Aug 1876 d. 17 May 1959
Joshua Robert Hodson
b. 30 Oct 1874 d. 20 Feb 1947
12
Ethelyn Hodson
[1.1.4.1.5.3.5.4.5.2.6.1]
b. 5 Apr 1903 d. 31 May 1999
12
Marva Hodson
[1.1.4.1.5.3.5.4.5.2.6.2]
b. 6 Nov 1905 d. 17 Dec 1992
12
Waldo Gee Hodson
[1.1.4.1.5.3.5.4.5.2.6.3]
b. 12 Jan 1910 d. 1 Apr 2002
12
Afton Hodson
[1.1.4.1.5.3.5.4.5.2.6.4]
b. 2 Jun 1914 d. 3 Dec 1940
12
Robert Gee Hodson
[1.1.4.1.5.3.5.4.5.2.6.5]
b. 6 Dec 1918 d. 2 Mar 1945
11
Don Carlos Gee
[1.1.4.1.5.3.5.4.5.2.7]
b. 20 Apr 1878 d. 11 Jan 1949
11
Bertha Victoria Gee
[1.1.4.1.5.3.5.4.5.2.8]
b. 31 May 1880 d. 27 Dec 1930
11
Martha Electa Gee
[1.1.4.1.5.3.5.4.5.2.9]
b. 28 Apr 1883 d. 13 May 1968
11
Adelia May Gee
[1.1.4.1.5.3.5.4.5.2.10]
b. 14 May 1885 d. 17 Feb 1964
9
Julia Priscilla Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.6]
b. 4 Mar 1815 d. 14 Aug 1906
Moses Martin
b. 1 Jun 1812 d. 5 May 1899
10
Julia Priscilla Martin
[1.1.4.1.5.3.5.4.6.1]
b. 1 Aug 1838 d. 14 Jan 1873
10
Napoleon J Martin
[1.1.4.1.5.3.5.4.6.2]
b. 1841
10
Rosella A Martin
[1.1.4.1.5.3.5.4.6.3]
b. 18 Aug 1844 d. 13 Sep 1909
10
Hiram Martin
[1.1.4.1.5.3.5.4.6.4]
b. 1 Aug 1847 d. Sep 1882
10
Joseph Martin
[1.1.4.1.5.3.5.4.6.5]
b. Abt 1850
10
Emma Cecelia Martin
[1.1.4.1.5.3.5.4.6.6]
b. Aug 1850 d. Jul 1882
10
Ada Martin
[1.1.4.1.5.3.5.4.6.7]
b. 1854
9
Silas Schellinger Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.7]
b. 6 Jun 1822 d. 11 Jun 1892
Elizabeth Orton
b. 1 Jun 1826 d. 27 Nov 1902
10
Silas Marion Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.7.1]
b. 17 Apr 1845 d. 20 Oct 1898
10
Julia Elizabeth Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.7.2]
b. 29 Jul 1848 d. 28 Oct 1878
Melvin Ross
b. 24 Sep 1842 d. 29 Nov 1920
11
Sarah Lovina Ross
[1.1.4.1.5.3.5.4.7.2.1]
b. 27 Mar 1863 d. 10 Jan 1919
11
Francis Marion Ross
[1.1.4.1.5.3.5.4.7.2.2]
b. 18 Apr 1866 d. 28 Mar 1949
11
Don Carlos Ross
[1.1.4.1.5.3.5.4.7.2.3]
b. 18 Jul 1867 d. 27 Oct 1918
11
James Melvin Ross
[1.1.4.1.5.3.5.4.7.2.4]
b. 16 Jan 1871 d. 25 Jul 1937
11
Mary Esther Ross
[1.1.4.1.5.3.5.4.7.2.5]
b. 14 Mar 1873 d. 2 Apr 1950
Hyrum Wild Stott
b. 27 Jun 1875 d. 19 Jan 1958
12
Leland Hyrum Stott
[1.1.4.1.5.3.5.4.7.2.5.1]
b. 17 Feb 1897 d. 28 Nov 1981
12
Roscoe Wild Stott
[1.1.4.1.5.3.5.4.7.2.5.2]
b. 28 Jul 1899 d. 26 May 1964
12
Asael R Stott
[1.1.4.1.5.3.5.4.7.2.5.3]
b. 23 Mar 1903 d. 21 Jun 1994
12
Percy Lynn Stott
[1.1.4.1.5.3.5.4.7.2.5.4]
b. 4 Dec 1920 d. 16 Nov 1995 [
=>
]
11
Silas Asahel Ross
[1.1.4.1.5.3.5.4.7.2.6]
b. 17 Jun 1875 d. 1895
11
Emma Ross
[1.1.4.1.5.3.5.4.7.2.7]
b. 7 Mar 1878 d. 1881
10
Frederick Asael Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.7.3]
b. 24 Jan 1850 d. 1850
10
Mary Jane Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.7.4]
b. 17 Jun 1853 d. 5 Jan 1917
John Thompson Rowley
b. 7 Nov 1847 d. 31 Jan 1925
11
John Henry Rowley
[1.1.4.1.5.3.5.4.7.4.1]
b. 10 Feb 1882 d. 14 Aug 1928
11
David Smith Rowley
[1.1.4.1.5.3.5.4.7.4.2]
b. 29 Aug 1883 d. 26 Jan 1955
11
Silas Rowley
[1.1.4.1.5.3.5.4.7.4.3]
b. 28 Oct 1885 d. 11 Oct 1949
11
Mary Ann Rowley
[1.1.4.1.5.3.5.4.7.4.4]
b. 5 Dec 1887 d. 20 Jul 1968
11
Franklin Irvin Rowley
[1.1.4.1.5.3.5.4.7.4.5]
b. 1 Jan 1890 d. 18 Jun 1951
11
Ephraim Rowley
[1.1.4.1.5.3.5.4.7.4.6]
b. 14 Oct 1893 bur. 14 Oct 1893
11
George Albert Rowley
[1.1.4.1.5.3.5.4.7.4.7]
b. 27 Nov 1894 d. 20 Jul 1976
10
Prince Henry Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.7.5]
b. 20 Oct 1858 d. 28 Nov 1922
10
Franklin D Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.7.6]
b. 29 Dec 1862 d. 16 Nov 1924
10
Vienna Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.7.7]
b. 16 Jun 1864 d. 17 Aug 1874
10
Martha Eliza Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.7.8]
b. 8 Oct 1869 d. 19 Jul 1956
Sarah Orton
b. 12 May 1830 d. 11 Dec 1912
10
Prince William Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.7.9]
b. 2 Aug 1859 d. 16 Nov 1909
10
Alexander Randolph Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.7.10]
b. 23 Dec 1861 d. 10 Sep 1865
10
David Hyrum Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.7.11]
b. 23 Dec 1863 d. 11 Mar 1865
10
Elias Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.7.12]
b. 16 May 1867 d. 18 Sep 1942
10
Sarah Esther Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.7.13]
b. 4 Nov 1869 d. 7 Nov 1869
10
Alonzo Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.7.14]
b. 5 Apr 1871 d. 24 Jan 1916
Ova Elizabeth Collins
b. 8 Aug 1879 d. 3 Jun 1960
11
Sarah Ethel Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.7.14.1]
b. 22 May 1901 d. 8 Mar 1997
+
William Edgar Johnson
b. 1897
+
Robert Neil Gladding
b. 14 Mar 1911 d. 21 Nov 1985
11
Rachel Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.7.14.2]
b. 25 Aug 1902 d. 12 May 1964
Russell John Quimby
b. 17 Apr 1892 d. 30 Apr 1979
12
Robbie Bobbie Russell Quimby
[1.1.4.1.5.3.5.4.7.14.2.1]
b. 4 Sep 1920 d. 25 Oct 1988
12
Melvin Jim Quimby
[1.1.4.1.5.3.5.4.7.14.2.2]
b. 10 Jan 1925 d. 3 Sep 2002
11
Fred Alonzo Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.7.14.3]
b. 13 Dec 1903 d. 1 Sep 1929
11
Lawrence Owen Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.7.14.4]
b. 19 Sep 1905 d. 21 Feb 1988
+
Martha Paget
b. 4 Oct 1918 d. 8 Mar 1999
11
Edith Elizabeth Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.7.14.5]
b. 25 Jan 1907 d. 31 Oct 1939
Jack Elmo Crampton
b. 6 May 1910 d. 25 Jun 1991
12
Peggy Lee Crampton
[1.1.4.1.5.3.5.4.7.14.5.1]
b. 6 Jul 1932 d. 30 Aug 2008
11
Arnold Elias Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.7.14.6]
b. 31 Oct 1910 d. 23 Jan 1976
Lavina Paget
b. 16 Apr 1916 d. 12 Feb 2013
12
Diane Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.7.14.6.1]
b. 29 Aug 1939 d. 12 Sep 1939
11
Grace Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.7.14.7]
b. 23 Feb 1913 d. 23 Nov 1997
Gordon Phillips Fraser
b. 6 Jun 1909 d. 9 Dec 1956
12
Gerald Gary Fraser
[1.1.4.1.5.3.5.4.7.14.7.1]
b. 30 Mar 1936 d. 11 Jan 2006
12
Daniel William Fraser
[1.1.4.1.5.3.5.4.7.14.7.2]
b. 13 Jul 1938 d. 19 Sep 1987
9
Martha Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.8]
b. 9 Jun 1817 d. 12 Oct 1902
Hiram Bell Bennett
b. 1 Mar 1823 d. 17 Aug 1912
10
Henry Bell Bennett
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.1]
b. Jun 1846 d. Jun 1846
10
Hyrum William Asahel Bennett
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.2]
b. 22 Nov 1848 d. 9 Jan 1849
10
Martha Eliza Bennett
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.3]
b. 24 Jan 1849 d. 6 May 1924
Silas Sanford Smith, Jr
b. 26 Oct 1830 d. 11 Oct 1910
11
Sarah Ann Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.3.1]
b. 11 Jul 1868 d. 2 Feb 1900
+
Jesse Moroni Smith
b. 21 Nov 1858 d. 14 Mar 1937
+
John Cranmer Dalton
b. 9 Jan 1857 d. 31 Aug 1906
11
Martha Eliza Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.3.2]
b. 17 Mar 1870 d. 7 Jan 1957
Thales Hastings Haskell, Jr
b. 20 Oct 1868 d. 23 Apr 1952
12
Green Dwight Haskell
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.3.2.1]
b. 8 Dec 1899 d. 25 Apr 1975 [
=>
]
12
Mark Smith Haskell
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.3.2.2]
b. 21 Apr 1901 d. 21 Feb 1958
12
Annie Haskell
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.3.2.3]
b. 10 Sep 1902 d. 11 Feb 1993 [
=>
]
12
Thales Edward Haskell
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.3.2.4]
b. 14 Oct 1904 d. 22 Dec 1982 [
=>
]
12
Hattie Haskell
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.3.2.5]
b. 3 Oct 1907 d. 1 Jan 1963
11
Curtis Bennett Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.3.3]
b. 23 Oct 1871 d. 28 Nov 1942
+
Ursula Pearl Harrison
b. 25 Jul 1879 d. 10 Nov 1960
11
Elias Austin Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.3.4]
b. 4 Mar 1874 d. 27 Jun 1925
Jessie Arlettia Block
b. 20 Feb 1879 d. 22 Apr 1958
12
Eva Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.3.4.1]
b. 8 Jun 1899 d. 22 Aug 1979 [
=>
]
12
Austin Block Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.3.4.2]
b. 26 Dec 1900 d. 1 Aug 1976 [
=>
]
12
Elias Penn Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.3.4.3]
b. 1 Oct 1902 d. 1 Feb 1976
12
Mack Bennett Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.3.4.4]
b. 23 Nov 1905 d. 1975 [
=>
]
12
Rex Poulson Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.3.4.5]
b. 3 Nov 1910 d. 22 Mar 1925
12
Amy Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.3.4.6]
b. 26 Sep 1913 d. 20 Mar 1994 [
=>
]
11
Emma Jane Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.3.5]
b. 4 Apr 1876 d. 16 Jan 1951
Edwin Cleveland Dibble
b. 1 Sep 1869 d. 28 Jan 1947
12
Edwin Smith Dibble
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.3.5.1]
b. 5 Dec 1901 d. 12 Sep 2003
12
George Smith Dibble
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.3.5.2]
b. 29 Mar 1904 d. 1 Jun 1992
12
Joseph Smith Dibble
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.3.5.3]
b. 6 Jun 1907 d. 17 Sep 1973 [
=>
]
12
Asael Smith Dibble
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.3.5.4]
b. 31 Jul 1910 d. 16 Dec 2000 [
=>
]
12
Verlie Dibble
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.3.5.5]
b. 25 Nov 1917 d. 19 Sep 1985
11
George Essex Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.3.6]
b. 24 Sep 1878 d. 26 May 1949
Vista May Rogers
b. 27 Aug 1880 d. 27 Jun 1954
12
May Rhue Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.3.6.1]
b. 8 Nov 1902 d. 6 Jul 1989
12
George Essex Smith, Jr
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.3.6.2]
b. 5 Aug 1904 d. 20 Jan 1985
12
Margaret Eliza Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.3.6.3]
b. 17 May 1906 d. 6 May 1996
12
Silas Bennett Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.3.6.4]
b. 16 Jan 1908 d. 27 Jan 1908
12
Sanford Snow Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.3.6.5]
b. 20 Feb 1911 d. 6 Dec 1928
12
Martha Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.3.6.6]
b. 20 Aug 1915 d. 21 Nov 1915
12
Milton Ralph Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.3.6.7]
b. 26 Oct 1918 d. 13 Aug 1986
11
Erastus Snow Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.3.7]
b. 18 Aug 1881 d. 16 Sep 1890
11
Hyrum Asahel Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.3.8]
b. 15 Sep 1883 d. 16 Jul 1941
Rebecca Pearl Hodson
b. 26 Oct 1883 d. 17 Oct 1965
12
Inez Myrtle Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.3.8.1]
b. 17 Nov 1905 d. 1 Aug 1994
12
Asahel Earl Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.3.8.2]
b. 29 Mar 1910 d. 3 Jan 1969 [
=>
]
12
Annie Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.3.8.3]
b. 24 Nov 1912 d. 23 Feb 1913
12
Fay Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.3.8.4]
b. 18 Feb 1915 d. 9 Jan 2000
12
Donald Hodson Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.3.8.5]
b. 19 May 1923 d. 12 Aug 1943
11
Lucy Edith Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.3.9]
b. 12 Aug 1886 d. 6 Jan 1963
David DuBois Dibble
b. 13 Sep 1876 d. 24 Apr 1975
12
Frances Dibble
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.3.9.1]
b. 18 Dec 1923 d. 16 Sep 1990 [
=>
]
12
David Smith Dibble
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.3.9.2]
b. 2 Apr 1928 d. 27 Dec 1993 [
=>
]
11
Joseph Frances Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.3.10]
b. 7 Apr 1889 d. 14 Feb 1920
Lavinia Ann Webster
b. 2 Mar 1890 d. 29 Nov 1962
12
Verlie W Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.3.10.1]
b. 14 Oct 1915 d. 17 Feb 2001 [
=>
]
12
Francis Bennett Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.3.10.2]
b. 29 Oct 1917 d. 12 Apr 1978
12
Arthur Agle Millecan
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.3.10.3]
b. 30 Jul 1922 d. 10 Apr 2003 [
=>
]
11
Clara Estella Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.3.11]
b. 4 Aug 1891 d. 10 May 1992
11
Verlie Dorcas Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.3.12]
b. 14 Oct 1894 d. 23 Dec 1894
10
Ezra Melanthorn Bennett
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.4]
b. 20 Oct 1851 d. 25 Aug 1852
10
Emily Jane Bennett
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.5]
b. 17 Jan 1854 d. 4 May 1903
John Aikens Smith
b. 19 Mar 1854 d. 9 Jan 1923
11
Emily Jane Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.5.1]
b. 5 May 1878 d. 21 Feb 1958
Levi Dunn
b. 9 Jan 1880 d. 9 Feb 1968
12
Emily Dunn
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.5.1.1]
b. 27 Mar 1911 d. 15 Jan 1988 [
=>
]
12
Alton Smith Dunn
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.5.1.2]
b. 19 Feb 1914 d. 6 Oct 1976
12
Leon Bennett Dunn
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.5.1.3]
b. 15 May 1916 d. 17 Feb 1975
12
Marcel Harmon Dunn
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.5.1.4]
b. 12 Jan 1919 d. 24 Aug 2002
11
Sarah Ann Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.5.2]
b. 23 Apr 1883 d. 22 Feb 1969
Joseph Beharm DePriest
b. 27 Jan 1881 d. 15 May 1969
12
Emily Lenella DePriest
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.5.2.1]
b. 22 Oct 1909 d. 17 Nov 1990
12
Lucy DePriest
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.5.2.2]
b. 29 Jun 1913 d. 4 Jan 1986 [
=>
]
12
Clarice DePriest
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.5.2.3]
b. 25 Dec 1915 d. 23 Oct 1999
12
Joseph Smith DePriest
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.5.2.4]
b. 21 Jul 1921 d. 5 Aug 1946 [
=>
]
11
Mary Hortense Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.5.3]
b. 19 Dec 1884 d. 8 Jun 1885
11
Martha Eliza Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.5.4]
b. 23 Aug 1886 d. 2 Apr 1980
David Earl Shawcroft
b. 17 Jun 1887 d. 25 Nov 1969
12
Zina Shawcroft
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.5.4.1]
b. 9 Mar 1913 d. 17 Jun 1916
12
Alice Shawcroft
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.5.4.2]
b. 11 Nov 1914 d. 4 Dec 2001 [
=>
]
12
David Amel Shawcroft
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.5.4.3]
b. 11 Dec 1916 d. 22 Feb 1944
12
Hazel Shawcroft
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.5.4.4]
b. 12 Nov 1918 d. 16 May 1964 [
=>
]
12
Earl Smith Shawcroft
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.5.4.5]
b. 6 Oct 1920 d. 27 Feb 2001 [
=>
]
12
Lucy Elizabeth Shawcroft
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.5.4.6]
b. 28 Jan 1923 d. 5 Jan 1926
12
John Bennett Shawcroft
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.5.4.7]
b. 26 Mar 1925 d. 29 Feb 2012 [
=>
]
11
John Aikens Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.5.5]
b. 5 Oct 1888 d. 4 Apr 1970
Ione Decker
b. 16 Aug 1890 d. 30 Dec 1963
12
Emma Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.5.5.1]
b. 9 Apr 1913 d. 7 Jan 2004
12
Majorie Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.5.5.2]
b. 6 Mar 1915 d. 8 May 1915
12
Majel Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.5.5.3]
b. 13 Feb 1918 d. 30 Nov 1997
12
John Decker Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.5.5.4]
b. 26 May 1920 d. 1 Jun 2002
12
Morris Montell Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.5.5.5]
b. 8 Oct 1924 d. 28 Jan 2007
+
Effie Elizabeth Pruitt Nokes
b. 18 Sep 1897 d. 25 Dec 1996
11
Lucy Elizabeth Smith
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.5.6]
b. 24 May 1893 d. 23 Oct 1944
10
Elizabeth Emma Bennett
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.6]
b. 2 Jul 1856 d. 26 Feb 1940
Joseph Henry Fisher
b. 18 Oct 1856 d. 21 Nov 1940
11
Zina Elizabeth Fisher
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.6.1]
b. 6 Nov 1880 d. 14 Feb 1890
11
Martha Hannah Lees Fisher
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.6.2]
b. 19 Feb 1882 d. 23 May 1958
John Delbert Bushnell
b. 26 May 1883 d. 7 Apr 1975
12
Kelleth Delbert Bushnell
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.6.2.1]
b. 12 Feb 1908 d. 21 Aug 1983 [
=>
]
12
Wanda Bushnell
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.6.2.2]
b. 22 Feb 1909 d. 28 Oct 2002 [
=>
]
12
Joseph Avon Bushnell
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.6.2.3]
b. 21 Apr 1910 d. 4 Jun 1988 [
=>
]
12
Linda Bushnell
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.6.2.4]
b. 23 Nov 1912 d. 25 May 2001 [
=>
]
12
Elizabeth Bushnell
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.6.2.5]
b. 11 Nov 1923 d. 27 Apr 1970
11
Mary Emily Fisher
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.6.3]
b. 25 Oct 1883 d. 18 Feb 1890
11
Joseph Lees Fisher
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.6.4]
b. 5 Oct 1885 d. 14 Feb 1890
11
Albert Hyrum Fisher
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.6.5]
b. 28 Dec 1888 d. 10 Jul 1973
Alta Jane Beckstrand
b. 18 Aug 1894 d. 8 Dec 1973
12
Lela Fisher
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.6.5.1]
b. 9 Aug 1917 d. 10 Mar 1920
12
Carol Fisher
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.6.5.2]
b. 7 Nov 1919 d. 31 Jul 2009 [
=>
]
12
Wanda Fisher
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.6.5.3]
b. 20 Jan 1922 d. 21 Sep 2007 [
=>
]
12
Living
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.6.5.4]
12
Beulah Fisher
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.6.5.5]
b. 27 Apr 1929 d. 8 Dec 2017 [
=>
]
12
Living
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.6.5.6]
11
Angie Celestine Fisher
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.6.6]
b. 2 May 1893 d. 25 Nov 1971
William Connell
b. 4 Jan 1888 d. 28 Mar 1976
12
Maxine Connell
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.6.6.1]
b. 21 Jan 1916 d. 1 Jan 2012
12
Beth Connell
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.6.6.2]
b. 1 Nov 1919 d. 16 Aug 1995
11
James Clyde Fisher
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.6.7]
b. 5 Jun 1896 d. 19 Nov 1977
+
Mabel Alice Bushnell
b. 15 May 1900 d. 2 Jun 1924
+
Giovanna Maria Botero
b. 2 Aug 1891 d. 8 Oct 1976
11
Cecil Neil Fisher
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.6.8]
b. 8 Jul 1898 d. 2 Oct 1983
Thelma Beckstrand
b. 23 Sep 1900 d. 19 Apr 1982
12
Cecil Fisher
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.6.8.1]
12
Jay Neil Fisher
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.6.8.2]
b. 1 Mar 1920 d. 13 Nov 2011 [
=>
]
12
Ione Fisher
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.6.8.3]
b. 13 Jul 1923 d. 18 Sep 2006 [
=>
]
10
Elias Austin Bennett
[1.1.4.1.5.3.5.4.8.7]
b. 26 Jan 1858 d. 1 May 1861
+
Jane Smith
b. 1775
8
Mary Smith
[1.1.4.1.5.3.5.5]
b. 4 Jun 1775 d. 24 May 1844
Isaac Pierce
b. 11 Oct 1773 d. 9 Nov 1847
9
Eunice Pierce
[1.1.4.1.5.3.5.5.1]
b. 29 Apr 1799 d. 9 Jun 1803
9
Laura Pierce
[1.1.4.1.5.3.5.5.2]
b. 12 Nov 1801 d. 1803
9
Miranda Pierce
[1.1.4.1.5.3.5.5.3]
b. 17 Jun 1803 d. 16 Sep 1831
9
Horace Pierce
[1.1.4.1.5.3.5.5.4]
b. 8 Jun 1805 d. 20 May 1877
9
John S. Pierce
[1.1.4.1.5.3.5.5.5]
b. 6 Jun 1807 d. 3 Apr 1854
9
Susan Pierce
[1.1.4.1.5.3.5.5.6]
b. 20 Jun 1809 d. 4 Apr 1855
9
Mary Pierce
[1.1.4.1.5.3.5.5.7]
b. 25 Apr 1811
9
Elisabeth Ann Pierce
[1.1.4.1.5.3.5.5.8]
b. 2 Sep 1817 d. 16 May 1855
+
Joseph Brimhall
b. 1771
+
Charles Smith
b. 1772
8
Samuel Smith
[1.1.4.1.5.3.5.6]
b. 15 Sep 1777 d. 1 Apr 1830
Frances Wilcox
b. 1780
9
Charles Smith
[1.1.4.1.5.3.5.6.1]
b. 16 Apr 1817
9
Laura Smith
[1.1.4.1.5.3.5.6.2]
b. 1 Mar 1819
9
Horace Jay Smith
[1.1.4.1.5.3.5.6.3]
b. 12 Jul 1821
9
Sarah Smith
[1.1.4.1.5.3.5.6.4]
b. 11 Jun 1824
9
Elizabeth Smith
[1.1.4.1.5.3.5.6.5]
b. 16 Jul 1826
8
Silas Sanford Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7]
b. 1 Oct 1779 d. 13 Sep 1839
Ruth Steven
b. 1782 d. 10 Jan 1864
9
Charles Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.1]
b. 11 Nov 1806 d. 7 May 1809
9
Charity Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.2]
b. 1 Apr 1808 d. 2 Jun 1888
+
Richard Smith
b. 1808
9
Curtis Stevens Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.3]
b. 29 Oct 1809 d. 23 Sep 1861
Celia Euphrasia Ross
b. 1829 d. 28 Jun 1857
10
Ezra Ross Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.3.1]
b. 24 Jul 1852 d. 17 May 1853
10
William Curtis Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.3.2]
b. 14 Apr 1857 d. 1 Mar 1945
9
Samuel Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.4]
b. 3 Oct 1811 d. 7 Mar 1826
9
Stephen Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.5]
b. 8 Jan 1815 d. 20 Feb 1891
9
Susan Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.6]
b. 19 Oct 1817 d. 20 Nov 1846
9
Asahel Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.7]
b. 12 Oct 1819 d. 15 May 1834
Mary Aikens
b. 13 Aug 1797 d. 27 Apr 1877
9
Silas Sanford Smith, Jr
[1.1.4.1.5.3.5.7.8]
b. 26 Oct 1830 d. 11 Oct 1910
Martha Eliza Bennett
b. 24 Jan 1849 d. 6 May 1924
10
Sarah Ann Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.1]
b. 11 Jul 1868 d. 2 Feb 1900
+
Jesse Moroni Smith
b. 21 Nov 1858 d. 14 Mar 1937
+
John Cranmer Dalton
b. 9 Jan 1857 d. 31 Aug 1906
10
Martha Eliza Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.2]
b. 17 Mar 1870 d. 7 Jan 1957
Thales Hastings Haskell, Jr
b. 20 Oct 1868 d. 23 Apr 1952
11
Green Dwight Haskell
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.2.1]
b. 8 Dec 1899 d. 25 Apr 1975
Lena Opal Richardson
b. 5 Oct 1905 d. 24 Sep 1990
12
Dwight Richardson Haskell
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.2.1.1]
b. 12 Nov 1926 d. 20 Dec 2012
11
Mark Smith Haskell
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.2.2]
b. 21 Apr 1901 d. 21 Feb 1958
+
Mary Louise Jensen
b. 27 Jan 1906 d. 27 Apr 1971
11
Annie Haskell
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.2.3]
b. 10 Sep 1902 d. 11 Feb 1993
Weir Ferguson Smith
b. 6 May 1901 d. 5 Mar 1988
12
Ross Kelvin Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.2.3.1]
b. 28 Jun 1931 d. 24 Jun 1994
12
Jo Anne Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.2.3.2]
b. 29 Jan 1935 d. 22 Jan 2003 [
=>
]
11
Thales Edward Haskell
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.2.4]
b. 14 Oct 1904 d. 22 Dec 1982
Edith Olson
b. 20 Oct 1902 d. 16 Dec 1980
12
Maralyne Haskell
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.2.4.1]
b. 23 Jun 1928 d. 5 Jun 2012 [
=>
]
11
Hattie Haskell
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.2.5]
b. 3 Oct 1907 d. 1 Jan 1963
+
Milton Hicks
b. 25 Oct 1915 d. 17 Mar 1983
10
Curtis Bennett Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.3]
b. 23 Oct 1871 d. 28 Nov 1942
+
Ursula Pearl Harrison
b. 25 Jul 1879 d. 10 Nov 1960
10
Elias Austin Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.4]
b. 4 Mar 1874 d. 27 Jun 1925
Jessie Arlettia Block
b. 20 Feb 1879 d. 22 Apr 1958
11
Eva Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.4.1]
b. 8 Jun 1899 d. 22 Aug 1979
Cecil Gee Sumner
b. 14 Aug 1905 d. 1 Apr 1991
12
Eve Smith Sumner
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.4.1.1]
b. 24 Jul 1935 d. 27 Sep 1972
11
Austin Block Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.4.2]
b. 26 Dec 1900 d. 1 Aug 1976
Helen Taggart
b. 29 Jul 1911 d. 22 Jul 2003
12
Austin Taggart Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.4.2.1]
b. 28 Nov 1938 d. 30 Oct 1987
11
Elias Penn Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.4.3]
b. 1 Oct 1902 d. 1 Feb 1976
+
Louise Harris
b. 25 Apr 1902 d. 28 Nov 1955
11
Mack Bennett Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.4.4]
b. 23 Nov 1905 d. 1975
Marion Eveline Jensen
b. 12 Apr 1908 d. 16 Sep 1979
12
Debra Annette Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.4.4.1]
b. 15 Dec 1951 d. 19 Apr 1987
11
Rex Poulson Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.4.5]
b. 3 Nov 1910 d. 22 Mar 1925
11
Amy Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.4.6]
b. 26 Sep 1913 d. 20 Mar 1994
Howard Eugene Baysinger
b. 23 Aug 1912 d. Nov 1978
12
Austin Smith Baysinger
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.4.6.1]
b. 26 Feb 1947 d. 10 Jan 2009
10
Emma Jane Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.5]
b. 4 Apr 1876 d. 16 Jan 1951
Edwin Cleveland Dibble
b. 1 Sep 1869 d. 28 Jan 1947
11
Edwin Smith Dibble
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.5.1]
b. 5 Dec 1901 d. 12 Sep 2003
+
Ruth Emily Gollaher
b. 9 Sep 1905 d. 26 Nov 1985
11
George Smith Dibble
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.5.2]
b. 29 Mar 1904 d. 1 Jun 1992
+
Cleone Atwood
b. 6 Jul 1908 d. 25 Nov 1990
11
Joseph Smith Dibble
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.5.3]
b. 6 Jun 1907 d. 17 Sep 1973
Blanche Woodruff McEwan
b. 6 Apr 1915 d. 23 Jun 1985
12
Elizabeth Jo Dibble
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.5.3.1]
b. 21 Apr 1937 d. 15 Feb 1970
11
Asael Smith Dibble
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.5.4]
b. 31 Jul 1910 d. 16 Dec 2000
Claire Fisher
b. 2 Dec 1913 d. 18 Mar 1993
12
Living
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.5.4.1]
11
Verlie Dibble
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.5.5]
b. 25 Nov 1917 d. 19 Sep 1985
+
Clyde Fielding Smith
b. 11 Oct 1903 d. 6 Dec 1980
10
George Essex Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.6]
b. 24 Sep 1878 d. 26 May 1949
Vista May Rogers
b. 27 Aug 1880 d. 27 Jun 1954
11
May Rhue Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.6.1]
b. 8 Nov 1902 d. 6 Jul 1989
+
William Milton Holmes
b. 12 Oct 1904 d. 19 Jan 1987
11
George Essex Smith, Jr
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.6.2]
b. 5 Aug 1904 d. 20 Jan 1985
+
Cella King
b. 6 Feb 1907 d. 8 Feb 1980
+
Laura Verina Crowther
b. 25 Nov 1903 d. 14 Jul 1989
11
Margaret Eliza Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.6.3]
b. 17 May 1906 d. 6 May 1996
+
Charles Frederick Chapman
b. 16 Oct 1898 d. 23 Nov 1969
11
Silas Bennett Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.6.4]
b. 16 Jan 1908 d. 27 Jan 1908
11
Sanford Snow Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.6.5]
b. 20 Feb 1911 d. 6 Dec 1928
11
Martha Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.6.6]
b. 20 Aug 1915 d. 21 Nov 1915
11
Milton Ralph Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.6.7]
b. 26 Oct 1918 d. 13 Aug 1986
+
Carol Rose Hiatt
b. 30 Aug 1921 d. 22 Sep 2002
10
Erastus Snow Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.7]
b. 18 Aug 1881 d. 16 Sep 1890
10
Hyrum Asahel Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.8]
b. 15 Sep 1883 d. 16 Jul 1941
Rebecca Pearl Hodson
b. 26 Oct 1883 d. 17 Oct 1965
11
Inez Myrtle Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.8.1]
b. 17 Nov 1905 d. 1 Aug 1994
+
William Uffo Uffens
b. 14 Jan 1908 d. 7 Mar 1997
11
Asahel Earl Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.8.2]
b. 29 Mar 1910 d. 3 Jan 1969
Nora Ann Porter
b. 11 Jul 1908 d. 16 Jun 1992
12
Donald Porter Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.8.2.1]
b. 3 Apr 1949 d. 4 Jul 2011
11
Annie Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.8.3]
b. 24 Nov 1912 d. 23 Feb 1913
11
Fay Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.8.4]
b. 18 Feb 1915 d. 9 Jan 2000
+
Woodrow Mitchell Lewis
b. 24 Feb 1914 d. 1 Aug 1984
11
Donald Hodson Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.8.5]
b. 19 May 1923 d. 12 Aug 1943
10
Lucy Edith Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.9]
b. 12 Aug 1886 d. 6 Jan 1963
David DuBois Dibble
b. 13 Sep 1876 d. 24 Apr 1975
11
Frances Dibble
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.9.1]
b. 18 Dec 1923 d. 16 Sep 1990
Scott Monroe McKay
b. 6 Sep 1921 d. 14 Mar 1983
12
Frances Ann McKay
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.9.1.1]
b. 28 Jul 1953 d. 18 Nov 2006
12
Living
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.9.1.2]
12
Donald David McKay
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.9.1.3]
b. 6 Apr 1956 d. 30 May 1956
+
Charles Dorsey Warren
b. 15 May 1905 d. 23 Dec 1983
11
David Smith Dibble
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.9.2]
b. 2 Apr 1928 d. 27 Dec 1993
12
Ann Dibble
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.9.2.1]
b. 13 Nov 1951 d. 30 May 2008
10
Joseph Frances Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.10]
b. 7 Apr 1889 d. 14 Feb 1920
Lavinia Ann Webster
b. 2 Mar 1890 d. 29 Nov 1962
11
Verlie W Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.10.1]
b. 14 Oct 1915 d. 17 Feb 2001
Gordon Beard Taylor
b. 3 May 1914 d. 16 Dec 2001
12
Roma Diane Taylor
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.10.1.1]
b. 21 Dec 1937 d. 24 Dec 1937
11
Francis Bennett Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.10.2]
b. 29 Oct 1917 d. 12 Apr 1978
+
Alice M Hummel
b. 1909
11
Arthur Agle Millecan
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.10.3]
b. 30 Jul 1922 d. 10 Apr 2003
Betty Margaret Stoddard
b. 15 Dec 1921 d. 21 Oct 2012
12
Arthur Stoddard Millecan
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.10.3.1]
b. 17 Jun 1961 d. 18 Jun 1961
10
Clara Estella Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.11]
b. 4 Aug 1891 d. 10 May 1992
10
Verlie Dorcas Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.12]
b. 14 Oct 1894 d. 23 Dec 1894
Clarinda Rich
b. 10 Jan 1835 d. 18 Mar 1864
10
Silas Sanford Smith, Jr
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.13]
b. 10 Jul 1853 d. 19 Jan 1911
10
Jesse Joel Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.14]
b. 4 Nov 1857 d. 12 Sep 1905
10
Leonora Abigail Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.15]
b. 22 Oct 1859 d. 26 Sep 1863
10
Stephen Augustus Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.16]
b. 1 Nov 1861 d. 21 Oct 1939
10
Ella Clarinda Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.17]
b. 9 Mar 1864 d. 2 Jun 1913
Sally Ann Ricks
b. 28 Dec 1832 d. 30 Jun 1864
10
John Aikens Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.18]
b. 19 Mar 1854 d. 9 Jan 1923
Emily Jane Bennett
b. 17 Jan 1854 d. 4 May 1903
11
Emily Jane Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.18.1]
b. 5 May 1878 d. 21 Feb 1958
Levi Dunn
b. 9 Jan 1880 d. 9 Feb 1968
12
Emily Dunn
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.18.1.1]
b. 27 Mar 1911 d. 15 Jan 1988 [
=>
]
12
Alton Smith Dunn
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.18.1.2]
b. 19 Feb 1914 d. 6 Oct 1976
12
Leon Bennett Dunn
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.18.1.3]
b. 15 May 1916 d. 17 Feb 1975
12
Marcel Harmon Dunn
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.18.1.4]
b. 12 Jan 1919 d. 24 Aug 2002
11
Sarah Ann Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.18.2]
b. 23 Apr 1883 d. 22 Feb 1969
Joseph Beharm DePriest
b. 27 Jan 1881 d. 15 May 1969
12
Emily Lenella DePriest
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.18.2.1]
b. 22 Oct 1909 d. 17 Nov 1990
12
Lucy DePriest
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.18.2.2]
b. 29 Jun 1913 d. 4 Jan 1986 [
=>
]
12
Clarice DePriest
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.18.2.3]
b. 25 Dec 1915 d. 23 Oct 1999
12
Joseph Smith DePriest
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.18.2.4]
b. 21 Jul 1921 d. 5 Aug 1946 [
=>
]
11
Mary Hortense Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.18.3]
b. 19 Dec 1884 d. 8 Jun 1885
11
Martha Eliza Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.18.4]
b. 23 Aug 1886 d. 2 Apr 1980
David Earl Shawcroft
b. 17 Jun 1887 d. 25 Nov 1969
12
Zina Shawcroft
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.18.4.1]
b. 9 Mar 1913 d. 17 Jun 1916
12
Alice Shawcroft
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.18.4.2]
b. 11 Nov 1914 d. 4 Dec 2001 [
=>
]
12
David Amel Shawcroft
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.18.4.3]
b. 11 Dec 1916 d. 22 Feb 1944
12
Hazel Shawcroft
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.18.4.4]
b. 12 Nov 1918 d. 16 May 1964 [
=>
]
12
Earl Smith Shawcroft
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.18.4.5]
b. 6 Oct 1920 d. 27 Feb 2001 [
=>
]
12
Lucy Elizabeth Shawcroft
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.18.4.6]
b. 28 Jan 1923 d. 5 Jan 1926
12
John Bennett Shawcroft
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.18.4.7]
b. 26 Mar 1925 d. 29 Feb 2012 [
=>
]
11
John Aikens Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.18.5]
b. 5 Oct 1888 d. 4 Apr 1970
Ione Decker
b. 16 Aug 1890 d. 30 Dec 1963
12
Emma Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.18.5.1]
b. 9 Apr 1913 d. 7 Jan 2004
12
Majorie Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.18.5.2]
b. 6 Mar 1915 d. 8 May 1915
12
Majel Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.18.5.3]
b. 13 Feb 1918 d. 30 Nov 1997
12
John Decker Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.18.5.4]
b. 26 May 1920 d. 1 Jun 2002
12
Morris Montell Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.18.5.5]
b. 8 Oct 1924 d. 28 Jan 2007
+
Effie Elizabeth Pruitt Nokes
b. 18 Sep 1897 d. 25 Dec 1996
11
Lucy Elizabeth Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.18.6]
b. 24 May 1893 d. 23 Oct 1944
10
Mary Eleanor Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.19]
b. 26 Sep 1857 d. 25 Nov 1888
10
Hortense Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.20]
b. 14 Oct 1859 d. 8 Sep 1945
10
Albert Ricks Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.21]
b. 1 Apr 1862 d. 17 May 1905
10
Hyrum Barton Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.8.22]
b. 16 Jun 1864 d. 9 Aug 1864
9
John Aikens Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.9]
b. 6 Jul 1832 d. 27 Nov 1838
9
Jesse Nathaniel Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.10]
b. 2 Dec 1834 d. 5 Jun 1906
Augusta Maria Outzen
b. 14 Jan 1854 d. 26 Apr 1932
10
Georgianna Bathsheba Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.1]
b. 16 Aug 1870 d. 14 May 1946
10
Augusta Gerhardina "Dina" Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.2]
b. 14 Jul 1872 d. 9 Jan 1940
10
Robert Christian Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.3]
b. 27 Nov 1874 d. 9 Apr 1920
10
Martha Amelia Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.4]
b. 17 Jul 1877 d. 10 Aug 1931
James Madison Flake
b. 8 Nov 1859 d. 4 Feb 1946
11
Donald Christian Flake
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.4.1]
b. 24 Oct 1897 d. 4 Jan 1979
11
Augusta Flake
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.4.2]
b. 4 Mar 1899 d. 1 Jun 1993
11
Silas Eugene Flake
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.4.3]
b. 9 Sep 1900 d. 19 Dec 1983
+
Ruth Whipple
b. 27 Dec 1910 d. 16 Sep 1994
11
Virgil Maeser Flake
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.4.4]
b. 24 Feb 1902 d. 19 Jan 1966
11
Joseph Marion Flake
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.4.5]
b. 8 Oct 1903 d. 24 Jan 1982
11
Thelma Flake
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.4.6]
b. 3 Jul 1905 d. 7 Dec 1923
11
Bruce Merlin Flake
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.4.7]
b. 27 Jan 1907 d. 10 May 1971
11
Vernon Smith Flake
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.4.8]
b. 23 Dec 1908 d. 15 Sep 1965
11
Mary Flake
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.4.9]
b. 10 Aug 1910 d. 27 Aug 1910
11
Anna Flake
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.4.10]
b. 24 Sep 1911 d. 20 Mar 2000
11
Ruth Flake
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.4.11]
b. 23 Nov 1913 d. 6 Jun 1975
11
Vincent Madison Flake
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.4.12]
b. 19 Jul 1915 d. 19 Aug 1988
11
Aften Flake
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.4.13]
b. 8 Aug 1916 d. 1 Oct 2008
11
Fost Wilson Flake
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.4.14]
b. 12 Mar 1918 d. 31 Aug 1997
10
Asahel Henry Smith, Sr
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.5]
b. 5 Dec 1880 d. 7 Sep 1947
10
Anna Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.6]
b. 6 Aug 1883 d. 8 Oct 1910
10
Rebecca Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.7]
b. 23 Oct 1886 d. 3 Nov 1960
10
Rachel Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.8]
b. 1 Jan 1889 d. 13 Jul 1940
10
Sophronia Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.9]
b. 8 Apr 1892 d. 11 Oct 1953
10
Natalia Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.10]
b. 3 Apr 1894 d. 2 Jun 1978
10
Millie Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.11]
b. 25 Dec 1897 d. 3 Oct 1931
Emma Seraphine West
b. 3 Jan 1836 d. 15 Oct 1910
10
Emma Seraphine Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.12]
b. 12 Aug 1853 d. 29 Dec 1909
10
Mary Josephine Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.13]
b. 23 Jan 1855 d. 17 Dec 1894
10
Hannah Daphne Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.14]
b. 22 Mar 1857 d. 10 May 1937
10
Eliza Snow Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.15]
b. 23 Feb 1859 d. 27 Dec 1927
10
Jesse Nathaniel Smith, Jr
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.16]
b. 16 May 1861 d. 13 Jul 1912
10
Sarah Elizabeth Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.17]
b. 2 Feb 1866 d. 15 Sep 1892
10
Silas Derryfield Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.18]
b. 9 Sep 1867 d. 26 Feb 1956
10
John Walter Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.19]
b. 10 Jun 1871 d. 7 May 1936
10
Samuel Francis Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.20]
b. 21 Nov 1873 d. 24 Jan 1954
Margaret Fletcher West
b. 22 May 1838 d. 1 Feb 1864
10
Adelaide Margaret Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.21]
b. 13 Feb 1857 d. 29 Oct 1927
10
Joseph West Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.22]
b. 6 Sep 1859 d. 22 Dec 1944
Janet Mauretta Johnson
b. 17 Dec 1848 d. 21 May 1933
10
Susan Janet Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.23]
b. 15 Sep 1868 d. 15 Dec 1960
Heber Jarvis
b. 14 Oct 1860 d. 8 Oct 1953
11
Heber Jarvis, Jr
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.23.1]
b. 15 Apr 1885 d. 26 Mar 1886
11
Jesse Rulon Jarvis
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.23.2]
b. 13 Jun 1886 d. 10 Jun 1960
Harriet Whipple
b. 23 Mar 1890 d. 24 Mar 1956
12
Jesse Rulon Jarvis, Jr
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.23.2.1]
b. 27 May 1909 d. 24 Jun 1990 [
=>
]
12
Marvin Earl Jarvis
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.23.2.2]
b. 24 Nov 1910 d. 26 Jan 1991 [
=>
]
12
Oliver Temple Jarvis
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.23.2.3]
b. 13 Feb 1913 d. 5 Aug 1914
12
Edith Jarvis
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.23.2.4]
b. 1 Jan 1915 d. 16 Nov 1979 [
=>
]
12
Grant Stanley Jarvis
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.23.2.5]
b. 31 Jan 1918 d. 14 May 1923
12
Erma Jarvis
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.23.2.6]
b. 21 Jul 1920 d. 23 Feb 1922
12
Eva Jarvis
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.23.2.7]
b. 6 Feb 1922 d. 26 Feb 1933
12
Rex Whipple Jarvis
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.23.2.8]
b. 27 Jan 1924 d. 12 Mar 1933
12
Wayne Heber Jarvis
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.23.2.9]
b. 14 Sep 1927 d. 1 May 1931
12
Joy Smith Jarvis
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.23.2.10]
b. 24 Feb 1930 d. 19 Sep 1930
11
Maude Jarvis
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.23.3]
b. 26 Jan 1888 d. 14 Mar 1974
11
George Jarvis
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.23.4]
b. 21 Mar 1889 d. 28 Aug 1981
11
Janet Jarvis
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.23.5]
b. 10 Feb 1891 d. 20 Oct 1944
11
Annie Jarvis
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.23.6]
b. 22 Apr 1892 d. 5 Apr 1893
11
Joseph Smith Jarvis
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.23.7]
b. 6 Mar 1894 d. 12 Jun 1989
11
Pearl Jarvis
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.23.8]
b. 7 Aug 1896 d. 12 Dec 1983
11
William Prior Jarvis
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.23.9]
b. 22 Sep 1898 d. 17 Mar 1973
11
Susie Jarvis
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.23.10]
b. 1 May 1901 d. 18 May 1929
11
Thomas Earl Jarvis
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.23.11]
b. 25 Apr 1903 d. 17 Apr 1906
11
Silas Fielding Jarvis
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.23.12]
b. 28 Feb 1905 d. 19 Oct 1983
11
Margaret Jarvis
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.23.13]
b. 1 Oct 1906 d. 19 Mar 1994
11
Ethel Jarvis
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.23.14]
b. 18 Oct 1908 d. 13 Sep 2006
11
Rudger LaVerl Jarvis
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.23.15]
b. 15 May 1911 d. 29 Jun 2002
10
Ellen Mauretta Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.24]
b. 20 Sep 1871 d. 1 Aug 1872
10
Sariah Anna Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.25]
b. 21 Feb 1873 d. 26 Dec 1922
10
Agnes Maud Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.26]
b. 11 Jul 1874 d. 7 Oct 1878
10
Julia Johnson Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.27]
b. 20 Oct 1875 d. 27 Apr 1956
10
Priscilla Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.28]
b. 10 May 1877 d. 17 Jan 1954
10
Editha Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.29]
b. 8 Sep 1878 d. 28 Jul 1931
10
Lucy Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.30]
b. 24 Jun 1880 d. 15 Nov 1951
William Howard Shumway
b. 20 Jul 1877 d. 20 Jun 1945
11
Donnetta Shumway
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.30.1]
b. 27 Oct 1899 d. 9 Jan 1955
11
Howard Burton Shumway
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.30.2]
b. 5 Mar 1901 d. 21 Jul 1933
11
Priscilla Shumway
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.30.3]
b. 2 Mar 1903 d. 15 Jan 1992
11
Kenneth Smith Shumway
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.30.4]
b. 13 Feb 1905 d. 10 Oct 1972
11
Charles Richard Shumway
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.30.5]
b. 12 Aug 1907 d. 17 Dec 1990
11
Elizabeth Shumway
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.30.6]
b. 25 Jan 1910 d. 6 Aug 1993
11
Jesse N Smith Shumway
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.30.7]
b. 18 Mar 1912 d. 14 Dec 2000
Leoma Blanche Peterson
b. 3 Sep 1910 d. 3 Mar 1998
12
Marlene Shumway
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.30.7.1]
b. 26 Jul 1936 d. 16 Oct 1984
11
Janet Smith Shumway
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.30.8]
b. 30 Jul 1914 d. 22 Dec 1982
11
Lucy Shumway
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.30.9]
b. 10 Oct 1917 d. 28 Nov 1998
11
Margaret Shumway
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.30.10]
b. 10 Feb 1920 d. 2 Feb 2013
11
Julia Rosalind Shumway
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.30.11]
b. 20 Apr 1922 d. 22 Aug 2011
11
Nephi Grant Shumway
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.30.12]
b. 8 Mar 1925 d. 15 Oct 1944
10
Margaret Fife Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.31]
b. 6 Sep 1882 d. 28 Mar 1969
10
Ruth Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.32]
b. 17 Mar 1884 d. 31 Dec 1956
10
Esther Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.33]
b. 26 Oct 1887 d. 8 Dec 1975
10
Elias Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.34]
b. 1 Aug 1889 d. 23 Dec 1961
10
Leah Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.35]
b. 13 Aug 1891 d. 17 Feb 1976
Emma Ellen Larson
b. 6 Apr 1863 d. 2 Jun 1943
10
Hyrum Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.36]
b. 15 Dec 1882 d. 22 Mar 1971
10
Caroline Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.37]
b. 19 Nov 1884 d. 19 Jan 1924
10
Don Carlos Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.38]
b. 26 Sep 1886 d. 28 Oct 1967
10
Lorana Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.39]
b. 29 Nov 1888 d. 25 Apr 1979
10
Lehi Larson Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.40]
b. 19 Mar 1891 d. 28 Oct 1918
10
George Albert Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.41]
b. 7 May 1893 d. 31 Jan 1965
10
Aikens Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.42]
b. 29 Jul 1899 d. 17 Jul 1960
10
Myrtle Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.43]
b. 25 Oct 1901 d. 10 Jan 1977
10
Matthias Foss Cowley Smith
[1.1.4.1.5.3.5.7.10.44]
b. 1 Oct 1905 d. 5 Feb 1990
8
Patriarch John Smith
[1.1.4.1.5.3.5.8]
b. 16 Jul 1781 d. 23 May 1854
Clarissa Loomis Lyman
b. 27 Jun 1790 d. 14 Feb 1854
9
Daughter Smith
[1.1.4.1.5.3.5.8.1]
b. 9 May 1816 d. 9 May 1816
9
George Albert Smith
[1.1.4.1.5.3.5.8.2]
b. 26 Jun 1817 d. 1 Sep 1875
Bathsheba Wilson Bigler
b. 3 May 1822 d. 20 Sep 1910
10
George Albert Smith
[1.1.4.1.5.3.5.8.2.1]
b. 7 Jul 1842 bur. 8 Jan 1876
10
Son Smith
[1.1.4.1.5.3.5.8.2.2]
b. Abt 1844
10
Bathsheba Kate Smith
[1.1.4.1.5.3.5.8.2.3]
b. 14 Aug 1844 d. 22 Dec 1920
10
Daughter Smith
[1.1.4.1.5.3.5.8.2.4]
b. Abt 1846
10
John Henry Smith
[1.1.4.1.5.3.5.8.2.5]
b. 4 Apr 1847 d. 4 Apr 1847
Nancy A Clement
b. 31 Oct 1815 d. 26 Mar 1847
10
Lydia Crane
[1.1.4.1.5.3.5.8.2.6]
b. 1800 d. Oct 1827
10
Nancy Alida Crane
[1.1.4.1.5.3.5.8.2.7]
b. 20 Mar 1807 d. Dec 1882
10
Nancy Adelia Smith
[1.1.4.1.5.3.5.8.2.8]
b. 20 Mar 1846 d. 17 Apr 1847
10
Ellen Smith
[1.1.4.1.5.3.5.8.2.9]
b. Dec 1846 d. Apr 1847
Lucy Messerve Smith
b. 9 Feb 1817 d. 5 Oct 1892
10
Don Carlos Smith
[1.1.4.1.5.3.5.8.2.10]
b. 11 Aug 1846 d. 21 Jul 1847
10
Joel Smith
[1.1.4.1.5.3.5.8.2.11]
b. 6 Aug 1850 d. 6 Aug 1850
Zilpha Stark
b. 3 Jul 1818 d. 19 Sep 1887
10
Zilpha Adelade Smith
[1.1.4.1.5.3.5.8.2.12]
b. 12 Mar 1846 d. 12 May 1846
10
Joseph Smith
[1.1.4.1.5.3.5.8.2.13]
b. 2 Jan 1850 d. 8 Oct 1850
10
Mary Amelia Smith
[1.1.4.1.5.3.5.8.2.14]
b. 14 Feb 1852 d. 20 Mar 1915
Sarah Ann Libby
b. 7 May 1818 d. 12 Jun 1851
10
John Henry Smith
[1.1.4.1.5.3.5.8.2.15]
b. 18 Sep 1848 d. 13 Oct 1911
Sarah Farr
b. 30 Oct 1849 d. 4 Feb 1921
11
John Henry Smith
[1.1.4.1.5.3.5.8.2.15.1]
b. 22 Feb 1868 d. 20 Sep 1868
11
George Albert Smith
[1.1.4.1.5.3.5.8.2.15.2]
b. 4 Apr 1870 d. 4 Apr 1951
Lucy Emily Woodruff
b. 10 Jan 1869 d. 5 Nov 1937
12
Emily Smith
[1.1.4.1.5.3.5.8.2.15.2.1]
b. 20 Nov 1895 d. 28 Feb 1973
12
Edith Elliott
[1.1.4.1.5.3.5.8.2.15.2.2]
b. 10 Nov 1899 d. 13 Jun 1977
12
George Albert Smith, Jr
[1.1.4.1.5.3.5.8.2.15.2.3]
b. 10 Sep 1905 d. 11 Oct 1969
11
Lorin Farr Smith
[1.1.4.1.5.3.5.8.2.15.3]
b. 22 Apr 1872 d. 9 Jul 1872
11
Don Carlos Smith
[1.1.4.1.5.3.5.8.2.15.4]
b. 18 Mar 1874 d. 5 Jan 1927
11
Ezra Chase Smith
[1.1.4.1.5.3.5.8.2.15.5]
b. 21 Sep 1876 d. 28 Apr 1951
11
Charles Warren Smith
[1.1.4.1.5.3.5.8.2.15.6]
b. 3 Aug 1879 d. 7 Dec 1879
11
Winslow Farr Smith
[1.1.4.1.5.3.5.8.2.15.7]
b. 19 Jan 1881 d. 25 Dec 1966
11
Nathaniel Libby Smith
[1.1.4.1.5.3.5.8.2.15.8]
b. 19 Jun 1883 d. 1 Jul 1935
11
Joseph Harmon Smith
[1.1.4.1.5.3.5.8.2.15.9]
b. 17 Dec 1884 d. 23 May 1942
11
Tirzah Priscilla Smith
[1.1.4.1.5.3.5.8.2.15.10]
b. 11 Jun 1887 d. 12 Jun 1951
11
Elsie Louise Smith
[1.1.4.1.5.3.5.8.2.15.11]
b. 19 Oct 1891 d. 26 Dec 1956
Josephine Groesbeck
b. 13 Oct 1857 d. 1 Nov 1948
11
Sarah Ann Smith
[1.1.4.1.5.3.5.8.2.15.12]
b. 2 Oct 1878 d. 11 Feb 1938
11
Nicholas Groesbeck Smith
[1.1.4.1.5.3.5.8.2.15.13]
b. 20 Jun 1881 d. 27 Oct 1945
11
Joseph Harmon Smith
[1.1.4.1.5.3.5.8.2.15.14]
b. 17 Dec 1884 d. 23 May 1942
11
Lucy Smith
[1.1.4.1.5.3.5.8.2.15.15]
b. 24 Dec 1887 d. 7 Sep 1900
11
Elizabeth Smith
[1.1.4.1.5.3.5.8.2.15.16]
b. 30 Jan 1890 d. 9 Mar 1973
11
Glen Grosbeck Smith
[1.1.4.1.5.3.5.8.2.15.17]
b. 19 Sep 1893 d. 19 Jun 1970
11
Arzella Smith
[1.1.4.1.5.3.5.8.2.15.18]
b. 5 Nov 1895 d. 4 Jan 1969
11
Josephine Smith
[1.1.4.1.5.3.5.8.2.15.19]
b. 3 Jan 1898 d. 12 Aug 1973
Hannah Maria Libby
b. 29 Jun 1828 d. 21 Sep 1906
10
Charles Warren Smith
[1.1.4.1.5.3.5.8.2.16]
b. 16 Jan 1849 d. 25 Jan 1903
10
Sarah Maria Smith
[1.1.4.1.5.3.5.8.2.17]
b. 1 Jan 1856 d. 16 Jan 1912
10
Eunice Albertine Smith
[1.1.4.1.5.3.5.8.2.18]
b. 6 Mar 1860 d. 4 Oct 1861
10
George Albert Smith
[1.1.4.1.5.3.5.8.2.19]
b. 7 Apr 1862 d. 28 Oct 1863
10
Grace Libby Smith
[1.1.4.1.5.3.5.8.2.20]
b. 14 May 1865 d. 27 Feb 1939
Susan Elizabeth West
b. 4 Dec 1833 d. 6 Jul 1935
10
Clarissa West Smith
[1.1.4.1.5.3.5.8.2.21]
b. 21 Apr 1859 d. 8 Mar 1930
10
Margaret West Smith
[1.1.4.1.5.3.5.8.2.22]
b. 6 Dec 1862 d. 18 Jun 1913
10
Elizabeth Smith
[1.1.4.1.5.3.5.8.2.23]
b. 28 Sep 1866 d. 6 Jan 1921
10
Priscilla Smith
[1.1.4.1.5.3.5.8.2.24]
b. 11 Jun 1869 d. 3 Nov 1907
10
Emma Pearl Smith
[1.1.4.1.5.3.5.8.2.25]
b. 19 Apr 1871 d. 6 Oct 1905
9
Caroline Clara Smith
[1.1.4.1.5.3.5.8.3]
b. 6 Jun 1820 d. 8 Jan 1895
Thomas Callister
b. 8 Jul 1821 d. 1 Dec 1880
10
Thomas Callister
[1.1.4.1.5.3.5.8.3.1]
b. 13 Sep 1846 d. 8 May 1847
10
Clarissa Callister
[1.1.4.1.5.3.5.8.3.2]
b. 28 May 1848 d. 4 Oct 1848
10
Clara Caroline Callister
[1.1.4.1.5.3.5.8.3.3]
b. 18 Apr 1850 d. 22 Sep 1892
10
Philomela Callister
[1.1.4.1.5.3.5.8.3.4]
b. 11 Jul 1851 d. 22 Feb 1879
10
Mary Maranda Callister
[1.1.4.1.5.3.5.8.3.5]
b. 17 Aug 1853 d. 14 May 1930
10
Samuel Jay Callister
[1.1.4.1.5.3.5.8.3.6]
b. 14 Jan 1856 d. 14 Jan 1856
10
Bathsheba Smith Callister
[1.1.4.1.5.3.5.8.3.7]
b. 21 Sep 1860 d. 1 Nov 1860
9
John Lyman Smith
[1.1.4.1.5.3.5.8.4]
b. 17 Nov 1828 d. 21 Feb 1898
8
Susannah Smith
[1.1.4.1.5.3.5.9]
b. 18 May 1783 d. 22 Mar 1849
+
John Hall
8
Stephen Smith
[1.1.4.1.5.3.5.10]
b. 23 Apr 1785 d. 25 Jul 1802
+
Sally Hadley
8
Sarah Smith
[1.1.4.1.5.3.5.11]
b. 16 May 1789 d. 27 May 1824
Joseph Sanford
b. 1785 d. 11 Sep 1825
9
Martin Sanford
[1.1.4.1.5.3.5.11.1]
b. 24 Sep 1811 d. 24 Nov 1817
9
Martin Sanford
[1.1.4.1.5.3.5.11.2]
b. 4 Nov 1812 d. 3 Dec 1820
9
Joseph Sanford
[1.1.4.1.5.3.5.11.3]
b. 1813 d. 1816
9
Charlette Sanford
[1.1.4.1.5.3.5.11.4]
b. 4 Mar 1814 d. Abt 1858
9
William Wallace Sanford
[1.1.4.1.5.3.5.11.5]
b. 13 Jun 1816 d. 1844
9
John Lyman Sanford
[1.1.4.1.5.3.5.11.6]
b. 20 May 1818
6
Rebecca Smith
[1.1.4.1.5.4]
b. 1 Oct 1715 d. 1 Mar 1794
John Balch
b. 25 Apr 1715 d. 31 Dec 1774
7
David Balch
[1.1.4.1.5.4.1]
b. 4 Jan 1740 d. 31 Jul 1801
7
Samuel Balch
[1.1.4.1.5.4.2]
b. 20 Mar 1742 d. 1820
7
John Balch
[1.1.4.1.5.4.3]
b. 26 Mar 1742 d. 25 Jul 1798
7
Robert Balch
[1.1.4.1.5.4.4]
b. 28 Jul 1743
7
Hannah Balch
[1.1.4.1.5.4.5]
b. 15 Mar 1746
7
Cornelius Balch
[1.1.4.1.5.4.6]
b. 26 Nov 1749 d. 21 May 1795
7
William Balch
[1.1.4.1.5.4.7]
b. 1752 d. 22 Mar 1764
7
Roger Balch
[1.1.4.1.5.4.8]
b. 26 May 1753 d. 8 Jan 1842
7
Rebecca Balch
[1.1.4.1.5.4.9]
b. 27 Mar 1758
6
Elizabeth Smith
[1.1.4.1.5.5]
b. 8 Jul 1718 d. 27 Mar 1753
Eleazar Gould
b. 29 May 1720 d. Jun 1795
7
Zaccheus Gould
[1.1.4.1.5.5.1]
b. 5 Feb 1743 d. 13 Feb 1823
7
John Gould
[1.1.4.1.5.5.2]
b. 5 Mar 1745
7
Hulda Gould
[1.1.4.1.5.5.3]
b. 1 Aug 1748 d. 11 Oct 1748
6
Hephzibah Smith
[1.1.4.1.5.6]
b. 12 May 1722 d. 15 Nov 1774
+
William Gallup
b. 4 Oct 1722 d. 29 Sep 1805
6
Robert Smith
[1.1.4.1.5.7]
b. 28 Feb 1724 d. 17 Mar 1795
Susannah Gould
b. 19 Feb 1723 d. Abt 1773
7
Elijah Smith
[1.1.4.1.5.7.1]
b. 5 Dec 1746 d. 5 Nov 1839
7
Elisha Smith
[1.1.4.1.5.7.2]
b. 4 Oct 1748
7
Joseph Smith
[1.1.4.1.5.7.3]
b. 9 Jun 1751
7
Elizabeth Smith
[1.1.4.1.5.7.4]
b. 20 Apr 1753 d. 10 Apr 1797
7
Rebeckah Smith
[1.1.4.1.5.7.5]
b. 8 May 1758 d. 8 Sep 1839
7
Thomas Smith
[1.1.4.1.5.7.6]
b. 10 Mar 1760 d. 3 Oct 1846
7
Silas Smith
[1.1.4.1.5.7.7]
b. 30 May 1772
7
Jedediah Smith
[1.1.4.1.5.7.8]
b. 30 May 1772
+
Abigail Waters
b. 5 Jun 1744
6
Susanna Smith
[1.1.4.1.5.8]
b. 2 May 1726 d. 29 Nov 1741
6
Hannah Smith
[1.1.4.1.5.9]
b. 15 Apr 1729 d. 17 Aug 1764
John Peabody
b. 10 Sep 1730 d. 29 Jan 1802
7
Hannah Peabody
[1.1.4.1.5.9.1]
b. 6 Oct 1757 d. 9 Oct 1802
7
Mehitable Peabody
[1.1.4.1.5.9.2]
b. 11 Mar 1759 d. 5 May 1759
7
Deborah Peabody
[1.1.4.1.5.9.3]
b. 27 Mar 1760 d. 27 Jan 1842
7
John Peaboddy
[1.1.4.1.5.9.4]
b. 11 Jul 1762 d. 22 Jan 1836
7
Mehitable Peabody
[1.1.4.1.5.9.5]
b. Aug 1764 d. 1 Dec 1849
6
John Smith
[1.1.4.1.5.10]
b. 13 Apr 1738 d. 1 Jul 1760
Martha Towne
b. 1739 d. Aft 1762
7
John Smith
[1.1.4.1.5.10.1]
b. Abt 1760
7
Amos Smith
[1.1.4.1.5.10.2]
b. 4 Feb 1762
5
Amye Smith
[1.1.4.1.6]
b. 16 Aug 1668 d. 22 Feb 1756
Joseph Towne
b. 2 Feb 1661 d. 18 May 1717
6
Captain Benjamin Towne
[1.1.4.1.6.1]
b. 10 May 1691 d. 11 Feb 1772
6
Daniel Towne
[1.1.4.1.6.2]
b. 22 Aug 1695
6
Jesse Towne
[1.1.4.1.6.3]
b. 5 Dec 1697 d. 28 Apr 1754
6
Nathan Towne
[1.1.4.1.6.4]
b. 1 Jun 1700 d. 5 Jan 1762
Jemima Perkins
b. Abt 1702
7
Jemima Towne
[1.1.4.1.6.4.1]
b. 20 May 1724 d. 15 Nov 1774
7
Nathaniel Towne, Jr
[1.1.4.1.6.4.2]
b. 16 Sep 1725 d. 1745
7
Eunes Towne
[1.1.4.1.6.4.3]
b. 4 Feb 1727
7
Sarah Towne
[1.1.4.1.6.4.4]
b. 1 Sep 1729
7
Prudence Towne
[1.1.4.1.6.4.5]
b. 16 Nov 1732
7
Anna Towne
[1.1.4.1.6.4.6]
b. 9 Mar 1734
7
Deacon Francis Towne
[1.1.4.1.6.4.7]
b. 27 Jul 1737 d. 11 Aug 1811
6
Amy Towne
[1.1.4.1.6.5]
b. 3 Feb 1704 d. 1747
6
Amos Towne
[1.1.4.1.6.6]
b. 2 Jul 1709 d. 14 Feb 1747
Mary Smith
b. 14 Aug 1711 d. 14 Nov 1785
7
Samuel Towne
[1.1.4.1.6.6.1]
b. Abt 1735
7
Amos Towne
[1.1.4.1.6.6.2]
b. Oct 1737 d. 8 Sep 1793
7
Daniel Towne
[1.1.4.1.6.6.3]
b. 28 Oct 1739
5
Sarah Smith
[1.1.4.1.7]
b. 26 Jun 1670 d. 28 Aug 1673
5
Nathaniel Smith
[1.1.4.1.8]
b. 7 Sep 1672 d. 1719
Mary Dickenson
b. 2 Feb 1672 d. 16 Aug 1718
6
Nathanial Smith
[1.1.4.1.8.1]
b. 1 Jan 1698 d. 13 Dec 1789
6
Joshua Smith
[1.1.4.1.8.2]
b. 11 Sep 1705 d. 28 Sep 1741
6
Hannah Smith
[1.1.4.1.8.3]
b. 7 Mar 1706
6
Martha Smith
[1.1.4.1.8.4]
b. 31 Jan 1708 d. 3 Oct 1794
6
Lydia Smith
[1.1.4.1.8.5]
b. 16 Mar 1711 d. 1 Oct 1804
Samuel Morton
b. 8 Sep 1709 d. 3 Jan 1793
7
Lydia Morton
[1.1.4.1.8.5.1]
b. 11 Aug 1731 d. 1778
7
Abigail Morton
[1.1.4.1.8.5.2]
b. 1 Sep 1733 d. 16 Sep 1823
7
Abner Morton
[1.1.4.1.8.5.3]
b. 17 Jan 1736 d. 5 Feb 1823
7
Jerusha Morton
[1.1.4.1.8.5.4]
b. 6 Mar 1737 d. 4 May 1834
Jonas Bradish
b. 7 Aug 1724
8
Daniel Bradish
[1.1.4.1.8.5.4.1]
b. 30 Apr 1761 d. 4 Nov 1855
8
Jonas Bradish
[1.1.4.1.8.5.4.2]
b. 13 Apr 1763
8
Aaron Bradish
[1.1.4.1.8.5.4.3]
b. 16 Jan 1766 d. 17 Feb 1832
8
Josiah Bradish
[1.1.4.1.8.5.4.4]
b. 20 Feb 1768 d. 1835
8
Joshua Bradish
[1.1.4.1.8.5.4.5]
b. 13 Apr 1770 d. 24 Apr 1845
8
James Bradish
[1.1.4.1.8.5.4.6]
b. 1772
8
Samuel Morton Bradish
[1.1.4.1.8.5.4.7]
b. Abt 1774 d. 1812
7
Lois Morton
[1.1.4.1.8.5.5]
b. 6 Apr 1740
7
Joshua Morton
[1.1.4.1.8.5.6]
b. 20 Oct 1744 d. 13 Feb 1827
7
Samuel Whitney Morton
[1.1.4.1.8.5.7]
b. 5 Nov 1746
7
Samuel Jillit Morton
[1.1.4.1.8.5.8]
b. 1748 d. 3 Jan 1793
7
Martha Morton
[1.1.4.1.8.5.9]
b. 8 Sep 1749 d. 11 Aug 1829
7
Thomas Morton
[1.1.4.1.8.5.10]
b. 15 Aug 1752 d. 20 Nov 1756
6
Mary Coleman
[1.1.4.1.8.6]
b. 14 Jul 1712 d. 28 Nov 1780
6
Jerusah Smith
[1.1.4.1.8.7]
b. 9 Jan 1713 d. 1809
5
Jacob Smith
[1.1.4.1.9]
b. 26 Jan 1674 d. 8 Dec 1748
Rebecca Symonds
b. 1686
6
Rebackah Smith
[1.1.4.1.9.1]
b. 1707 d. Abt 1794
6
Joseph Smith
[1.1.4.1.9.2]
b. 23 May 1713
6
Keziah Smith
[1.1.4.1.9.3]
b. 30 Apr 1716 d. 23 Aug 1762
6
Moses Smith
[1.1.4.1.9.4]
b. 1718
6
Ruth Smith
[1.1.4.1.9.5]
b. 21 Sep 1721 d. 1744
6
Nathaniel Smith
[1.1.4.1.9.6]
b. 5 Aug 1724 d. Jan 1802
5
Mariah Smith
[1.1.4.1.10]
b. 18 Dec 1677 d. 17 Jan 1739
+
Peter Shumway
b. 6 Jun 1678 d. 17 May 1741
4
Thomas French
[1.1.4.2]
b. 1635 d. 14 Dec 1661
Mary Adams
b. 1639 d. 1721
5
Mary French
[1.1.4.2.1]
b. 9 Mar 1662 d. 13 May 1753
+
John Stiles
b. 20 Jun 1661 d. 16 May 1700
5
Thomas French
[1.1.4.2.2]
b. 21 May 1666 d. 2 Jan 1752
5
Abigail French
[1.1.4.2.3]
b. 27 Jun 1668 d. 17 Oct 1703
5
Hannah French
[1.1.4.2.4]
b. 30 Jan 1670 d. 11 Mar 1717
Jethro Wheeler
b. 1664 d. 1725
6
Jethro Wheeler
[1.1.4.2.4.1]
b. 19 Aug 1692
6
Benjamin Wheeler
[1.1.4.2.4.2]
b. 23 May 1694 d. 1 Jan 1779
6
Moses Wheeler
[1.1.4.2.4.3]
b. Abt 1700 d. 23 Feb 1789
6
Abigail Wheeler
[1.1.4.2.4.4]
b. 1702
6
John Wheeler
[1.1.4.2.4.5]
b. 1710
5
William French
[1.1.4.2.5]
b. 30 Nov 1673 d. 15 Nov 1764
Abigail Wiggin
b. 14 Sep 1678 d. 1748
6
Bradstreet French
[1.1.4.2.5.1]
b. 1699
6
Thomas French
[1.1.4.2.5.2]
b. 1701
6
Abigail French
[1.1.4.2.5.3]
b. Abt 1703
6
David French
[1.1.4.2.5.4]
b. 1705
6
William French
[1.1.4.2.5.5]
b. 1707 d. Jan 1790
6
Mary French
[1.1.4.2.5.6]
b. 1712 d. 1803
6
Hannah French
[1.1.4.2.5.7]
b. 1714
6
Sarah French
[1.1.4.2.5.8]
b. 1718
6
Simon French
[1.1.4.2.5.9]
b. 1722
5
Hester French
[1.1.4.2.6]
b. 2 Jan 1676
4
John French
[1.1.4.3]
b. Feb 1635 d. 15 Mar 1706
Phebe Keyes
b. 17 Jun 1639 d. 14 May 1701
5
Mary French
[1.1.4.3.1]
b. 1661 d. 27 Sep 1730
Stephen Pearson
b. 11 Nov 1664 d. 28 Jan 1706
6
Elisabeth Pearson
[1.1.4.3.1.1]
b. 5 Aug 1685 d. 10 May 1746
6
Stephen Pearson
[1.1.4.3.1.2]
b. Abt 1686 d. 18 Mar 1772
6
Martha Pearson
[1.1.4.3.1.3]
b. 6 Jul 1689 d. 26 Oct 1752
6
Mary Pearson
[1.1.4.3.1.4]
b. 7 Jun 1690
6
Jonathan Pearson
[1.1.4.3.1.5]
b. 9 Oct 1693 d. 11 Dec 1693
6
Patience Pearson
[1.1.4.3.1.6]
b. 1697 d. 29 Dec 1773
6
Hephsibah Pearson
[1.1.4.3.1.7]
b. 20 Jan 1699 d. 30 Oct 1771
5
Richard French
[1.1.4.3.2]
b. 18 Aug 1676 d. 13 May 1757
Elizabeth
b. Abt 1676
6
Amy French
[1.1.4.3.2.1]
b. 6 May 1700 d. 8 Mar 1757
6
Elizabeth French
[1.1.4.3.2.2]
b. 3 Aug 1702 d. 1746
6
Phebe French
[1.1.4.3.2.3]
b. 1704 d. 1 Apr 1705
6
Ephraim French
[1.1.4.3.2.4]
b. 15 May 1708 d. 1780
6
Experience French
[1.1.4.3.2.5]
b. 3 Aug 1710 d. 4 Mar 1791
6
Richard French
[1.1.4.3.2.6]
b. 1712 d. 1759
6
Hepzibath French
[1.1.4.3.2.7]
b. 9 Dec 1714 d. 1745
6
John French
[1.1.4.3.2.8]
b. 1716 d. 1775
6
Alice French
[1.1.4.3.2.9]
b. 30 Apr 1720 d. 2 Dec 1778
4
Samuel French
[1.1.4.4]
b. 1639 d. 1688
+
Elizabeth Kemp
b. 1645
4
Ephraim French
[1.1.4.5]
b. 2 Mar 1643 d. Sep 1716
4
Sarah French
[1.1.4.6]
b. Abt 1645 d. 19 May 1717
Nathaniel Hayden
b. 6 Jun 1648 d. 20 Apr 1706
5
Experience Hayden
[1.1.4.6.1]
b. 15 May 1679 d. Aft 1719
5
Hannah Hayden
[1.1.4.6.2]
b. 9 Feb 1680 d. 20 Oct 1736
Joseph Kelsey
b. 25 Dec 1673 d. 8 Mar 1740
6
Jemima Kelsey
[1.1.4.6.2.1]
b. 22 Mar 1701 d. 28 Sep 1775
6
Margaret Kelsey
[1.1.4.6.2.2]
b. 8 Oct 1702 d. 17 Sep 1752
6
Keziah Kelsey
[1.1.4.6.2.3]
b. 5 Mar 1704 d. 1763
Josiah Wilcox
b. 4 Apr 1706
7
Eliab Wilcox
[1.1.4.6.2.3.1]
b. 23 Feb 1731 d. 20 Jan 1810
7
Anna Wilcox
[1.1.4.6.2.3.2]
b. 23 Apr 1735 d. 30 Oct 1835
7
Roswell Wilcox
[1.1.4.6.2.3.3]
b. 31 Dec 1736 d. 23 May 1819
7
Josiah Wilcox
[1.1.4.6.2.3.4]
b. 4 May 1739 d. 18 Jan 1832
7
Keziah Wilcox
[1.1.4.6.2.3.5]
b. 3 Jun 1742
7
Elizabeth Wilcox
[1.1.4.6.2.3.6]
b. 11 Mar 1744
7
Abner Wilcox
[1.1.4.6.2.3.7]
b. 10 Jul 1748 d. 20 Jan 1837
7
John Wilcox
[1.1.4.6.2.3.8]
b. 4 Oct 1756 d. 1860
Marjorie Deborah Day
b. Abt 1759 d. 1825
8
Amy Wilcox
[1.1.4.6.2.3.8.1]
b. 1780
8
Hannah Wilcox
[1.1.4.6.2.3.8.2]
b. 1782 d. 1864
William Porter
b. 18 Mar 1782 d. 1855
9
David Porter
[1.1.4.6.2.3.8.2.1]
b. Mar 1799 d. 8 Dec 1879
9
Ruth Hannah Porter
[1.1.4.6.2.3.8.2.2]
b. 11 Jun 1800 d. Aft 10 Mar 1862
9
John Porter
[1.1.4.6.2.3.8.2.3]
b. 1804
9
Latney Day Porter
[1.1.4.6.2.3.8.2.4]
b. 1808 d. 30 Sep 1880
Sophrona Brown
b. 28 Feb 1828 d. 5 Mar 1907
10
John P. Porter
[1.1.4.6.2.3.8.2.4.1]
b. 14 Jun 1844 d. 1917
10
Samuel Porter
[1.1.4.6.2.3.8.2.4.2]
b. 10 Dec 1846 d. 15 Sep 1858
10
Aaron Porter
[1.1.4.6.2.3.8.2.4.3]
b. 1849 d. 19 Sep 1872
10
Case Henry Porter
[1.1.4.6.2.3.8.2.4.4]
b. 3 Jul 1850 d. 18 May 1876
10
Palmer Porter
[1.1.4.6.2.3.8.2.4.5]
b. 12 Dec 1852 d. 14 Apr 1853
10
Clara Porter
[1.1.4.6.2.3.8.2.4.6]
b. 9 May 1855 d. 29 Sep 1887
10
Latney James Porter
[1.1.4.6.2.3.8.2.4.7]
b. 22 Jun 1857 d. 12 Mar 1926
Elizabeth Gleockler
b. 8 May 1860 d. 3 May 1900
11
Roseltha Porter
[1.1.4.6.2.3.8.2.4.7.1]
b. 5 Aug 1881 d. 23 Nov 1963
Joseph Grant Wareing
b. 9 Jul 1872 d. 28 Feb 1942
12
George Grant Wareing
[1.1.4.6.2.3.8.2.4.7.1.1]
b. 21 Aug 1902 d. 8 Sep 1970 [
=>
]
12
Marvin LaVere "Pete" Wareing
[1.1.4.6.2.3.8.2.4.7.1.2]
b. 26 Jul 1908 d. 15 Mar 1991 [
=>
]
11
George Porter
[1.1.4.6.2.3.8.2.4.7.2]
b. 16 Jan 1883 d. 21 Feb 1971
11
Bertha Arvilla Porter
[1.1.4.6.2.3.8.2.4.7.3]
b. 10 Aug 1885 d. 29 Mar 1962
11
Floyd Porter
[1.1.4.6.2.3.8.2.4.7.4]
b. 4 Jul 1891 d. 13 Mar 1963
11
Clarence Dewey Porter
[1.1.4.6.2.3.8.2.4.7.5]
b. 1 Mar 1898 d. 19 Mar 1972
11
Irvin Charles Porter
[1.1.4.6.2.3.8.2.4.7.6]
b. 15 Mar 1900 d. 21 May 1985
10
Loretta Hannah Porter
[1.1.4.6.2.3.8.2.4.8]
b. 5 Jan 1860 d. 1906
10
Harriet Porter
[1.1.4.6.2.3.8.2.4.9]
b. 5 May 1861 d. 15 Jul 1929
10
Ulysses S Grant Porter
[1.1.4.6.2.3.8.2.4.10]
b. 8 May 1864 d. 30 Aug 1917
10
P. Geary Porter
[1.1.4.6.2.3.8.2.4.11]
b. 2 Oct 1866 d. 30 Aug 1917
10
Sarah C Porter
[1.1.4.6.2.3.8.2.4.12]
b. 3 Apr 1870 d. Feb 1932
10
Clarence Lee Porter
[1.1.4.6.2.3.8.2.4.13]
b. 7 Jan 1872 d. 5 Feb 1962
9
Minor T Porter
[1.1.4.6.2.3.8.2.5]
b. 12 Mar 1810 d. 26 Dec 1893
9
Amy Porter
[1.1.4.6.2.3.8.2.6]
b. 1 Apr 1812 d. 26 Mar 1910
9
William Porter, Jr
[1.1.4.6.2.3.8.2.7]
b. 1814 d. 16 Jan 1864
9
Clarinda Porter
[1.1.4.6.2.3.8.2.8]
b. 1816 d. 1910
9
Daniel Porter
[1.1.4.6.2.3.8.2.9]
b. 14 Mar 1818 d. 7 Sep 1905
9
Israel Porter
[1.1.4.6.2.3.8.2.10]
b. 18 Feb 1820 d. 15 Mar 1898
9
Albert Porter
[1.1.4.6.2.3.8.2.11]
b. Jun 1822 d. 23 Dec 1855
9
Ensel Porter
[1.1.4.6.2.3.8.2.12]
b. 1827
8
Nathan Wilcox
[1.1.4.6.2.3.8.3]
b. 1785 d. 1877
8
Ruth Hannah Wilcox
[1.1.4.6.2.3.8.4]
b. Abt 1788
8
Samuel Wilcox
[1.1.4.6.2.3.8.5]
b. 1789 d. 22 Aug 1848
8
Gideon Wilcox
[1.1.4.6.2.3.8.6]
b. 16 Oct 1792
8
John Day Wilcox
[1.1.4.6.2.3.8.7]
b. 14 Oct 1794 d. 4 Mar 1865
8
Chloe Wilcox
[1.1.4.6.2.3.8.8]
b. 1795
8
Susan Wilcox
[1.1.4.6.2.3.8.9]
b. Abt 1797
8
Nancy Wilcox
[1.1.4.6.2.3.8.10]
b. 1799 d. 11 May 1860
8
Mary Wilcox
[1.1.4.6.2.3.8.11]
b. 22 Apr 1804 d. 30 Jun 1885
6
Joseph Kelsey
[1.1.4.6.2.4]
b. 10 Oct 1708 d. 7 Aug 1800
6
Damaris Kelsey
[1.1.4.6.2.5]
b. 13 Apr 1711 d. 3 Jun 1803
6
Silas Kelsey
[1.1.4.6.2.6]
b. 11 Feb 1713 d. 18 Mar 1713
6
Abagail Kelsey
[1.1.4.6.2.7]
b. 16 Aug 1717 d. 5 Sep 1743
6
Gideon Kelsey
[1.1.4.6.2.8]
b. 1 Apr 1718 d. 5 Mar 1764
6
Josiah Kelsey
[1.1.4.6.2.9]
b. 1 Aug 1721 d. 9 Feb 1758
6
Abner Kesley
[1.1.4.6.2.10]
b. 10 Aug 1724
5
Concurrence Hayden
[1.1.4.6.3]
b. Oct 1685 d. Oct 1753
5
Sarah Hayden
[1.1.4.6.4]
b. Abt 1690
2
Sybil Scudamore
[1.2]
c. 16 Oct 1589 d. 1571