Home Page
|
What's New
|
Photos
|
Histories
|
Headstones
|
Reports
|
Surnames
Search
First Name:
Last Name:
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Suomalainen
Svenska
Ann Empson
1438 - 1475 (37 years)
Submit Photo / Document
Individual
Descendants
Relationship
Timeline
Submit Photo / Doc
Worksheet
Family
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Ann Empson
[1]
b. 1438 d. 1475
John Spencer
b. 1433 d. 1475
2
Robert Spencer
[1.1]
b. 1460 d. Abt 1521
Anne Peake
b. Abt 1455 d. 1520
3
John Spencer
[1.1.1]
b. Abt 1477 d. Bef 5 Feb 1532
3
Alice Spencer
[1.1.2]
b. 1486 d. 5 Jan 1518
Thomas Deacon
b. Abt 1482
4
Thomas Deacon
[1.1.2.1]
b. Abt 1514 d. 20 Jun 1582
Joan Allen
b. 1525
5
Thomas Deacon
[1.1.2.1.1]
b. Abt 1548
Joan Allen
b. Abt 1550 d. 1582
6
Audrie Deacon
[1.1.2.1.1.1]
b. 1552 d. Bef 1582
6
Marie Deacon
[1.1.2.1.1.2]
b. Abt 1556
6
Roger Deacon
[1.1.2.1.1.3]
b. Abt 1563 bur. Dec 1616
6
Thomas Deacon
[1.1.2.1.1.4]
b. 1570 d. 24 Oct 1663
Martha Field
b. 16 Feb 1579 d. 24 Oct 1663
7
Phebe Deacon
[1.1.2.1.1.4.1]
b. 3 Apr 1597 d. 20 Sep 1663
Zaccheus Gould
b. 1 Oct 1589 d. 30 Mar 1668
8
Phebe Gould
[1.1.2.1.1.4.1.1]
b. 27 Sep 1620 d. 7 May 1686
Thomas Perkins
b. 28 Apr 1622 d. 7 May 1686
9
John Perkins
[1.1.2.1.1.4.1.1.1]
b. Abt 1641 d. 19 May 1688
Deborah Browning
c. 31 Jan 1646 d. Aft 1704
10
Thomas Perkins
[1.1.2.1.1.4.1.1.1.1]
b. 4 May 1667 d. 3 Jun 1709
9
Phebe Perkins
[1.1.2.1.1.4.1.1.2]
b. 1644 d. 1680
Jacob Towne
c. 11 Mar 1632 d. 20 Feb 1713
10
Phebe Towne
[1.1.2.1.1.4.1.1.2.1]
b. 4 May 1666 d. 3 Jan 1669
10
Joanna Towne
[1.1.2.1.1.4.1.1.2.2]
b. 22 Jan 1668 d. 1736
+
Thomas Nichols
b. 20 Jan 1670 d. Aft 1725
10
Mary Towne
[1.1.2.1.1.4.1.1.2.3]
b. 27 Mar 1670 d. Aft 1695
+
Isaac Larrabee
b. 1663 d. May 1755
10
Susanna Towne
[1.1.2.1.1.4.1.1.2.4]
b. 24 Dec 1671 d. 13 Sep 1766
John Cummings
b. 7 Jun 1666 d. 3 Jul 1706
11
Joseph Cummings
[1.1.2.1.1.4.1.1.2.4.1]
b. Jan 1689 d. 22 Apr 1794
11
Sarah Cummings
[1.1.2.1.1.4.1.1.2.4.2]
b. 30 May 1690 d. Aft 1728
11
John Cummings
[1.1.2.1.1.4.1.1.2.4.3]
b. 12 Jun 1692
11
Isaac Cummings
[1.1.2.1.1.4.1.1.2.4.4]
b. 25 Dec 1695 d. Abt 1752
11
David Cummings
[1.1.2.1.1.4.1.1.2.4.5]
b. 15 Apr 1698 d. 2 Apr 1765
11
Mary Cummings
[1.1.2.1.1.4.1.1.2.4.6]
b. 13 May 1700 d. Bef 1732
11
Susannah Cummings
[1.1.2.1.1.4.1.1.2.4.7]
b. 13 Jan 1702 d. 1723
11
Hannah Cummings
[1.1.2.1.1.4.1.1.2.4.8]
c. 21 Dec 1718 d. 1718
10
Joseph Towne
[1.1.2.1.1.4.1.1.2.5]
b. 22 Mar 1673 d. 28 May 1757
10
Sarah Towne
[1.1.2.1.1.4.1.1.2.6]
b. 30 Dec 1675 d. 1 Nov 1760
10
John Towne
[1.1.2.1.1.4.1.1.2.7]
b. 20 Feb 1678 d. 28 Mar 1714
Abigail Stanley
b. 6 Aug 1688 d. 1 Sep 1743
11
John Towne
[1.1.2.1.1.4.1.1.2.7.1]
b. 5 Dec 1729 d. 9 Jan 1820
11
Abigail Towne
[1.1.2.1.1.4.1.1.2.7.2]
b. 29 Sep 1721 d. 8 Dec 1739
11
Catherine Towne
[1.1.2.1.1.4.1.1.2.7.3]
b. 14 Dec 1725
11
Bartholemew Towne
[1.1.2.1.1.4.1.1.2.7.4]
b. 4 Apr 1713 d. 9 May 1783
11
Samuel Towne
[1.1.2.1.1.4.1.1.2.7.5]
b. 1717 d. Nov 1778
11
Johnathan Towne
[1.1.2.1.1.4.1.1.2.7.6]
b. 5 Dec 1729 bur. Jul 1771
10
Martha Towne
[1.1.2.1.1.4.1.1.2.8]
b. 19 May 1680 d. 24 Feb 1753
+
Isaac Leach
b. Abt 1676
10
Phebe Towne
[1.1.2.1.1.4.1.1.2.9]
b. 23 Jul 1685 d. 10 Jun 1736
John Gould
b. 25 Aug 1687 d. 20 Jul 1762
11
John Gould
[1.1.2.1.1.4.1.1.2.9.1]
b. 9 Apr 1712 d. 18 Apr 1712
11
Kezia Gould
[1.1.2.1.1.4.1.1.2.9.2]
b. 10 May 1718 d. 28 Dec 1798
11
Stephen Gould
[1.1.2.1.1.4.1.1.2.9.3]
b. 6 Jul 1724 d. 1798
11
Ruth Gould
[1.1.2.1.1.4.1.1.2.9.4]
b. 16 Sep 1727 d. Not Needed
11
Esther Gould
[1.1.2.1.1.4.1.1.2.9.5]
b. 10 Aug 1732 d. 1785
9
Zaccheus Perkins
[1.1.2.1.1.4.1.1.3]
b. 1647 d. 1 Dec 1732
9
Thomas Perkins
[1.1.2.1.1.4.1.1.4]
b. Abt 1648 d. Apr 1722
Sarah Wallis
b. 24 Jul 1658 d. 1719
10
Thomas Perkins
[1.1.2.1.1.4.1.1.4.1]
b. 9 Dec 1688
10
Hannah Perkins
[1.1.2.1.1.4.1.1.4.2]
b. 1690 d. 1 Jan 1747
10
Robert Perkins
[1.1.2.1.1.4.1.1.4.3]
b. Abt 1695 d. 15 Jan 1750
10
Samuel Perkins
[1.1.2.1.1.4.1.1.4.4]
b. 18 May 1712 d. 1 Jan 1747
9
Martha Perkins
[1.1.2.1.1.4.1.1.5]
b. 1649 d. Abt 1728
John Lamson
b. Nov 1642 d. Bef 23 Jun 1717
10
John Lamson, Jr
[1.1.2.1.1.4.1.1.5.1]
b. 21 Nov 1669 d. 1 Sep 1760
10
Phebe Lamson
[1.1.2.1.1.4.1.1.5.2]
b. 13 Aug 1673 d. 23 May 1753
10
William Lamson
[1.1.2.1.1.4.1.1.5.3]
b. 19 Aug 1675 d. 1750
10
Martha Lamson
[1.1.2.1.1.4.1.1.5.4]
b. 21 Aug 1677 d. Abt 1724
10
Thomas Lamson
[1.1.2.1.1.4.1.1.5.5]
b. 3 Jan 1682 d. Jul 1767
10
Samuel Lamson
[1.1.2.1.1.4.1.1.5.6]
b. 25 Feb 1684 d. 17 Nov 1760
9
Mary Perkins
[1.1.2.1.1.4.1.1.6]
b. 1651 d. 1728
William Howlet
b. Abt 1650 d. 1718
10
John Howlet
[1.1.2.1.1.4.1.1.6.1]
b. Abt 1676 d. 7 Sep 1735
9
Judith Perkins
[1.1.2.1.1.4.1.1.7]
b. 11 Jul 1655 d. Abt 1743
Nathaniel Browne
b. 1645 bur. 13 Sep 1717
10
Nathaniel Brown
[1.1.2.1.1.4.1.1.7.1]
b. Abt 1676 d. Abt 12 Feb 1759
10
Elizabeth Brown
[1.1.2.1.1.4.1.1.7.2]
b. Abt 1678 d. Bef 1716
9
Elisha Perkins
[1.1.2.1.1.4.1.1.8]
b. 1656 d. 18 Feb 1741
Catharine Towne
b. 25 Feb 1662 d. 2 Jul 1714
10
Thomas Perkins
[1.1.2.1.1.4.1.1.8.1]
b. 15 Oct 1681 d. 1761
10
Elisha Perkins
[1.1.2.1.1.4.1.1.8.2]
b. 27 May 1683 d. 24 Dec 1704
10
John Perkins
[1.1.2.1.1.4.1.1.8.3]
b. 12 Aug 1685 d. 22 Jun 1750
10
Catharina Perkins
[1.1.2.1.1.4.1.1.8.4]
c. 3 Feb 1687
10
Phebe Perkins
[1.1.2.1.1.4.1.1.8.5]
b. 10 Aug 1690
10
Jacob B Perkins
[1.1.2.1.1.4.1.1.8.6]
c. 13 Nov 1692 d. 18 Nov 1758
10
Ruth Perkins
[1.1.2.1.1.4.1.1.8.7]
c. 10 May 1695 d. 9 Jun 1695
10
Mary Perkins
[1.1.2.1.1.4.1.1.8.8]
b. 30 Mar 1699 d. 1737
10
Joseph Perkins
[1.1.2.1.1.4.1.1.8.9]
b. 10 May 1702 d. 1777
9
Timothy Perkins
[1.1.2.1.1.4.1.1.9]
b. 6 Jun 1661 d. 18 Dec 1751
8
Mary Gould
[1.1.2.1.1.4.1.2]
b. 12 Dec 1621 d. 15 Nov 1690
John Reddington
b. Abt 1617 d. 15 Nov 1690
9
Daniel Reddingtion
[1.1.2.1.1.4.1.2.1]
b. 1645 d. 28 Sep 1732
9
Eliza Reddington
[1.1.2.1.1.4.1.2.2]
b. 1648
9
John Reddington
[1.1.2.1.1.4.1.2.3]
b. 20 Jun 1649 d. 8 Mar 1650
9
Mary Reddington
[1.1.2.1.1.4.1.2.4]
b. 4 May 1651 d. 13 Mar 1682
9
Phebe Reddington
[1.1.2.1.1.4.1.2.5]
b. 7 Apr 1655 d. 1 Oct 1696
9
Martha Reddington
[1.1.2.1.1.4.1.2.6]
b. 7 Apr 1655 d. 7 Aug 1731
9
Sarah Reddington
[1.1.2.1.1.4.1.2.7]
c. 12 Mar 1658 d. 8 Jul 1689
8
Martha Gould
[1.1.2.1.1.4.1.3]
b. 19 Jun 1623 d. Abt 1699
John Newmarch
b. 1619 d. 7 Mar 1696
9
John Newmarch
[1.1.2.1.1.4.1.3.1]
b. Abt 1649 d. 21 May 1733
9
Thomas Newmarch
[1.1.2.1.1.4.1.3.2]
b. Abt 1651 d. 9 Jul 1716
9
Sara Newmarch
[1.1.2.1.1.4.1.3.3]
b. Abt 1652 d. 1751
9
Phebe Newmarch
[1.1.2.1.1.4.1.3.4]
b. Abt 1652
9
Martha Newmarch
[1.1.2.1.1.4.1.3.5]
b. Abt 1652 d. 7 Jul 1720
9
Zaccheus Neumarch
[1.1.2.1.1.4.1.3.6]
b. Abt 1653 d. 1731
8
Priscilla Gould
[1.1.2.1.1.4.1.4]
b. 27 Sep 1628 d. 16 Sep 1663
John Wildes
b. 1620 d. 14 May 1705
9
Sarah Wildes
[1.1.2.1.1.4.1.4.1]
b. 1647 d. 12 May 1711
9
Elizabeth Wildes
[1.1.2.1.1.4.1.4.2]
b. 1653 d. 25 Jun 1718
Lieutenant Benjamin Jones
b. 31 Jul 1651 d. 25 Jun 1718
10
Lieutenant Thomas Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1]
b. 13 Mar 1680 d. 4 Nov 1763
Mary Meacham
b. 12 Jan 1684 d. 8 Nov 1744
11
Mary Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.1]
b. 22 Apr 1709 d. 4 Nov 1780
Abraham Whipple
b. Abt 1709 d. 3 Oct 1768
12
Bathsheba Whipple
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.1.1]
b. 2 Feb 1731
12
Abraham Whipple, Jr
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.1.2]
b. 18 Mar 1734
12
Mary Whipple
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.1.3]
b. 1 Mar 1735 d. 6 Dec 1823
12
Samuel Whipple
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.1.4]
b. 7 Jan 1737 d. 28 Sep 1762
12
Joseph Whipple
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.1.5]
b. 18 May 1740 [
=>
]
12
Luther Whipple
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.1.6]
b. 7 Mar 1743 d. 1830 [
=>
]
12
Anna Whipple
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.1.7]
b. 17 Feb 1744 d. 1811 [
=>
]
12
Calvin Whipple
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.1.8]
b. 17 Aug 1745 d. 10 Nov 1762
12
Deborah Whipple
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.1.9]
b. 6 Aug 1747
12
Daniel Whipple
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.1.10]
b. 7 Sep 1749 d. 1798 [
=>
]
12
Thomas Whipple
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.1.11]
b. 16 Mar 1751 d. 1833 [
=>
]
11
Jerusha Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.2]
b. 8 Apr 1711 d. 28 Oct 1763
Jonathan Spencer
b. 15 Mar 1704 d. 19 May 1763
12
Jerusha Spencer
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.2.1]
b. 6 May 1732 d. 21 Feb 1815
12
Jonathan Spencer
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.2.2]
b. 11 Mar 1734 d. 16 Jul 1813
12
Obadiah Spencer
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.2.3]
b. 7 Mar 1735 d. 1806
12
Ruth Spencer
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.2.4]
b. 12 Feb 1737
12
Israel Spencer
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.2.5]
b. 14 Feb 1740 d. 22 Sep 1747
12
Zachariah Spencer
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.2.6]
b. 28 Mar 1742 d. 4 Oct 1762
12
Jehid Spencer
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.2.7]
b. 17 Feb 1744 d. 16 Sep 1747
12
Jehiel Spencer
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.2.8]
b. 17 Feb 1747 d. 24 Feb 1816
12
Israel Spencer
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.2.9]
b. Abt 1748 d. 22 Jan 1825
12
Hulda Spencer
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.2.10]
b. 7 Jan 1750
12
Sybil Spencer
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.2.11]
b. 17 Mar 1759
11
Thomas Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.3]
b. 15 Mar 1712 d. 1746
+
Sarah Parsons
b. 10 Mar 1704 d. 25 Aug 1747
11
Bathsheba Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.4]
b. 16 Feb 1714 d. 12 May 1715
11
Captain Israel Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.5]
b. 18 May 1715 d. 28 Dec 1798
Jemima Clark
b. 5 Mar 1726 d. 3 Jun 1798
12
Israel Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.5.1]
b. 2 Sep 1753 d. 1 Sep 1812
12
Jemima Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.5.2]
b. 5 Jun 1755 d. 22 Dec 1818
12
Samuel Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.5.3]
b. 31 Jan 1745 d. 4 Sep 1747
12
William Clark Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.5.4]
b. Abt 1771
12
Thomas Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.5.5]
b. 1751 d. 1832
12
Mary Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.5.6]
b. Abt 1745 d. Abt 1826
12
Isaac Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.5.7]
b. 25 Apr 1764 d. 16 Jul 1830
12
Submit Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.5.8]
b. 18 Oct 1757 d. 29 Dec 1785
11
Isaac Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.6]
b. 29 Jan 1717 d. 3 Jul 1784
+
Elizabeth
b. Abt 1718
11
Bathsheba Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.7]
b. 25 Feb 1720 d. 9 Jan 1775
John Pease
b. 1726 d. Abt 1810
12
John Chauncey Pease
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.7.1]
b. Abt 1750 d. 1843
12
Thomas Pease
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.7.2]
c. 17 Dec 1754 d. 2 Feb 1810
12
Gideon Pease
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.7.3]
b. 18 Nov 1757 d. 1824
12
Elizabeth Pease
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.7.4]
b. 29 May 1756 d. 24 Sep 1827
12
Bathsheba Pease
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.7.5]
b. 1759
12
Sarah Pease
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.7.6]
b. 14 May 1762
12
Simeon Pease
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.7.7]
b. Abt 1764 d. 1827
11
Elizabeth Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.8]
b. 1722 d. 1804
David Kellogg
b. Abt 1718 d. 6 Mar 1747
12
Mary Kellogg
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.8.1]
b. 13 Jun 1748 d. 20 Jun 1810
12
Samuel Kellogg
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.8.2]
b. 6 Aug 1749
12
David Kellogg
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.8.3]
b. 16 Nov 1750 d. 22 Apr 1774
12
Elizabeth Kellogg
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.8.4]
b. 15 Aug 1752 d. 15 Mar 1807
12
Seth Kellogg
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.8.5]
b. 14 Mar 1754 d. 20 Jun 1801
12
Phineas Kellogg
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.8.6]
b. 6 Apr 1756 d. 26 Jul 1806
12
Ruth Kellogg
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.8.7]
b. 3 Sep 1757 d. 14 Jun 1837
12
Enoch Kellogg
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.8.8]
b. 12 Jul 1759 d. 31 Aug 1759
12
Elzina Kellogg
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.8.9]
b. Abt 1761
12
Lucretia Kellogg
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.8.10]
b. Abt 1763 d. 14 Jun 1814
12
Enoch Kellogg
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.8.11]
b. 9 Oct 1768 d. 29 Oct 1847
11
Samuel Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.9]
b. 29 Oct 1724 d. 19 Sep 1743
+
Anna Taylor
b. Abt 1727
11
Son Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.1.10]
b. Abt 1726
10
Priscilla Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.2]
b. 10 Jun 1681 d. Aft 1719
John Howard
b. 1683
11
Elezebath Howard
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.2.1]
b. 20 May 1707
11
Priscilla Howard
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.2.2]
b. 20 Sep 1705 bur. Abt 1759
11
John Howard
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.2.3]
b. 24 May 1719
10
Benjamin Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.3]
b. 1683 d. 5 Feb 1754
Anna Prior
b. 30 Mar 1690 d. 5 Feb 1754
11
Benjamin Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.3.1]
b. 9 Jun 1710 d. 13 Oct 1794
11
Joseph Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.3.2]
b. 3 Jan 1712 d. 26 Jan 1757
Sarah Wood
b. Abt 1712
12
Joseph Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.3.2.1]
b. 1 Nov 1734 d. 29 Jan 1816 [
=>
]
12
Tryphena Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.3.2.2]
b. 22 Mar 1737
12
Silas Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.3.2.3]
b. 1 Apr 1740
12
Daniel Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.3.2.4]
b. 31 Jan 1743 d. 23 Mar 1792
12
Esther Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.3.2.5]
b. Abt 1757 d. 1821
11
Annie Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.3.3]
b. 9 Sep 1714 d. 22 Sep 1808
11
Levi Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.3.4]
b. 9 Nov 1716 d. 23 May 1766
11
Abi Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.3.5]
b. 15 Mar 1718
11
Hannah Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.3.6]
b. 23 Sep 1720 d. 11 Oct 1806
11
Naomi Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.3.7]
b. 28 Mar 1721
11
Zebblon Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.3.8]
b. 9 Jun 1723 d. 27 Sep 1776
11
Lucrettia Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.3.9]
b. 1729
10
Ebenezer Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.4]
b. 17 Apr 1684 d. 20 Jul 1755
Priscilla Smith
b. Abt 1684 d. Bef 1725
11
Elezebath Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.4.1]
b. 11 May 1713
11
Ebenezer Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.4.2]
b. 12 Jan 1715
11
Gersham Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.4.3]
b. 1717
11
Hannah Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.4.4]
b. 11 Jul 1720 d. 8 Jul 1764
11
Martha Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.4.5]
b. Abt 1721
Jemima Gary
b. 10 Mar 1705 d. Aft 1747
11
North Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.4.6]
b. 18 Apr 1731
11
Zerviah Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.4.7]
b. 28 Mar 1734
11
Abigail Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.4.8]
b. 4 Jan 1735
11
Nathan Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.4.9]
b. Jun 1738
11
Thomas Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.4.10]
b. 30 Aug 1741 d. 13 Oct 1762
11
Margan Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.4.11]
b. 8 Aug 1747
10
Elizabeth Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.5]
b. 26 Jan 1685 d. 2 Jan 1769
Isaac Osborn
b. Abt 1680
11
George Osborn
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.5.1]
c. 20 Oct 1724
10
Ephraim Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.6]
b. 31 Jul 1688 d. 3 Sep 1688
10
Samuel Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.7]
b. 22 Sep 1690 d. 4 Nov 1691
10
Eleazer Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.8]
b. 12 Apr 1693 d. 20 Apr 1755
Mehitable Gary
b. 11 Jul 1697 d. Aft 1735
11
Son Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.8.1]
b. 21 May 1721 d. 26 Jun 1721
11
Eleazer Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.8.2]
b. 26 Jan 1723 d. 23 May 1758
11
Mehitable Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.8.3]
b. 4 Jun 1725 d. 28 Apr 1766
11
Elizabeth Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.8.4]
b. 23 Jul 1727 d. 28 Apr 1766
11
Benjamin Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.8.5]
b. 8 May 1730
11
Ebenezer Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.8.6]
10
Gersham Jones
[1.1.2.1.1.4.1.4.2.9]
b. 26 Oct 1695 d. 19 Oct 1696
9
Priscilla Wildes
[1.1.2.1.1.4.1.4.3]
b. 6 Apr 1658 d. 23 Mar 1688
9
Martha Wildes
[1.1.2.1.1.4.1.4.4]
b. 13 May 1660 d. 1685
9
Nathan Wildes
[1.1.2.1.1.4.1.4.5]
b. 14 Dec 1662 d. 17 Mar 1663
8
John Gould
[1.1.2.1.1.4.1.5]
b. 21 Jun 1635 d. 26 Jan 1710
Sarah Baker
b. 9 Mar 1641 d. 20 Jan 1709
9
John Gould
[1.1.2.1.1.4.1.5.1]
b. 1 Dec 1662 d. 5 Nov 1724
9
Sarah Gould
[1.1.2.1.1.4.1.5.2]
b. 18 Dec 1664 d. 4 Dec 1723
9
Thomas Gould
[1.1.2.1.1.4.1.5.3]
b. 14 Feb 1666 d. 24 Jun 1752
9
Samuel Gould
[1.1.2.1.1.4.1.5.4]
b. 9 Mar 1669 d. 1 Dec 1724
9
Zaccheus Gould
[1.1.2.1.1.4.1.5.5]
b. 26 Mar 1672 d. 29 Apr 1739
Elizabeth Curtis
b. 15 Dec 1679 d. 21 Jun 1740
10
Elizabeth Gould
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.1]
b. 3 Feb 1703 d. 17 Sep 1742
Edmund Towne
b. 7 May 1699 d. 27 May 1745
11
Eliza Goold
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.1.1]
b. 29 Dec 1723
11
Debora Goold
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.1.2]
b. Abt 1724 d. 12 Mar 1812
11
Mehitabel Goold
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.1.3]
b. 10 Nov 1728
11
Edmund Towne
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.1.4]
b. 10 Sep 1733
11
Nathaniel Gould
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.1.5]
b. 17 Nov 1734 d. Dec 1781
11
Zaccheus Town
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.1.6]
b. 20 Feb 1736 d. 1740
11
Bathsheba Towne
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.1.7]
b. 28 Mar 1740 d. 1741
11
Mary Towne
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.1.8]
b. 7 Sep 1742 d. 1742
10
Mary Gould
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.2]
c. 1 Mar 1704 d. 3 Nov 1787
10
John Gould
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.3]
b. 29 Jan 1709 d. 21 Jun 1778
10
Sarah Gould
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.4]
b. 28 Jan 1711 d. 1743
10
Abigail Gould
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.5]
b. 12 Aug 1715 d. Abt 1737
10
Zaccheus Gould
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.6]
b. 7 Nov 1717 d. 2 Jan 1793
10
Eleazar Gould
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.7]
b. 29 May 1720 d. Jun 1795
Elizabeth Smith
b. 8 Jul 1718 d. 27 Mar 1753
11
Zaccheus Gould
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.7.1]
b. 5 Feb 1743 d. 13 Feb 1823
11
John Gould
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.7.2]
b. 5 Mar 1745
11
Hulda Gould
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.7.3]
b. 1 Aug 1748 d. 11 Oct 1748
10
Susannah Gould
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.8]
b. 19 Feb 1723 d. Abt 1773
Robert Smith
b. 28 Feb 1724 d. 17 Mar 1795
11
Elijah Smith
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.8.1]
b. 5 Dec 1746 d. 5 Nov 1839
11
Elisha Smith
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.8.2]
b. 4 Oct 1748
11
Joseph Smith
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.8.3]
b. 9 Jun 1751
11
Elizabeth Smith
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.8.4]
b. 20 Apr 1753 d. 10 Apr 1797
11
Rebeckah Smith
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.8.5]
b. 8 May 1758 d. 8 Sep 1839
11
Thomas Smith
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.8.6]
b. 10 Mar 1760 d. 3 Oct 1846
11
Silas Smith
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.8.7]
b. 30 May 1772
11
Jedediah Smith
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.8.8]
b. 30 May 1772
10
Priscilla Gould
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.9]
b. 4 Aug 1707 d. 25 Sep 1744
Captain Samuel T Smith
b. 26 Jan 1714 d. 14 Nov 1785
11
Priscilla Smith
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.9.1]
b. 26 Dec 1735 d. 7 Dec 1792
Jacob Kimball
b. 5 Mar 1731 d. 8 Nov 1810
12
Benjamin Kimball
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.9.1.1]
b. 23 Jan 1757 d. 19 Aug 1776
12
Mehetiball Kimbal
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.9.1.2]
b. 3 Dec 1758 d. 12 Nov 1790
12
Jacob Kimball
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.9.1.3]
b. 2 Feb 1761 d. 24 Jul 1826
12
Priscilla Kimball
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.9.1.4]
b. 10 Mar 1763 d. 2 Sep 1792
12
Ann Kimball
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.9.1.5]
b. 2 Jun 1765 d. 12 Sep 1789
12
Lucy Kimball
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.9.1.6]
b. 6 Sep 1767 bur. Sep 1790
12
Lydia Kimball
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.9.1.7]
b. 28 Jan 1770 d. 20 Apr 1795
12
David Kimball
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.9.1.8]
b. 26 Apr 1772 d. 20 Nov 1795
12
Samuel Kimball
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.9.1.9]
b. Dec 1774 d. 10 Sep 1775
11
Samuel Smith, III
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.9.2]
b. 28 Oct 1737 d. 14 Nov 1785
Rebecca Lovett
b. 9 Jun 1737 d. Aft 1760
12
Rebekah Smith
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.9.2.1]
b. 29 Jun 1760 d. 15 Apr 1816
12
Lydia Smith
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.9.2.2]
b. 14 Apr 1762 d. 19 Dec 1850 [
=>
]
12
Susanna Smith
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.9.2.3]
b. 9 Mar 1764 d. 18 Sep 1781
12
Samuel Smith
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.9.2.4]
b. 1 Apr 1766 d. 21 Mar 1811
12
Elizabeth Mary Smith
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.9.2.5]
b. 31 Mar 1768
12
Jacob Smith
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.9.2.6]
b. 24 May 1770
12
Anna Smith
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.9.2.7]
b. 8 Jan 1772
12
Son Smith
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.9.2.8]
b. 13 Apr 1773
12
Benjamin Smith
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.9.2.9]
b. 20 Feb 1776 d. 2 Oct 1778
11
Vashti Smith
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.9.3]
b. 5 Oct 1739 d. Aft 1776
Jacobs Hobbs
b. 16 Jun 1745 d. 20 Jan 1823
12
Jacob Hobbs
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.9.3.1]
b. 21 Feb 1768
12
Abraham Hobbs
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.9.3.2]
b. 16 Dec 1769
12
Samuel Hobbs
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.9.3.3]
b. 21 Feb 1772
12
Vashti Hobbs
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.9.3.4]
b. 2 Feb 1774 d. 14 Feb 1836
12
Abigail Hobbs
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.9.3.5]
b. 10 Aug 1776
Soloman Curtis
b. 10 Jul 1739 d. Apr 1766
12
Solomon Curtis
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.9.3.6]
b. 13 Apr 1766
11
Susannah Smith
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.9.4]
b. 24 Jan 1741 d. 13 May 1766
Isaac Hobbs
b. 20 Apr 1743 d. 3 Jun 1815
12
Sarah Hobbs
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.9.4.1]
b. 16 Nov 1766 d. 27 Jan 1823
12
Susannah Hobbs
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.9.4.2]
b. 16 Nov 1766 d. Abt 1870
12
Priscilla Hobbs
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.9.4.3]
b. 28 May 1769 d. 18 May 1771
12
Isaac Hobbs
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.9.4.4]
b. 19 Aug 1770 d. Abt 1870
12
Elizabeth Hobbs
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.9.4.5]
b. 16 Jan 1773 d. 14 Nov 1850
12
Munson Hobbs
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.9.4.6]
b. 5 Mar 1775 d. Abt 1870
12
Samuel Hobbs
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.9.4.7]
b. 1 Dec 1776 d. Abt 1870
12
Humphrey Hobbs
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.9.4.8]
b. 5 Sep 1779 d. Abt 1870
12
Solomon Hobbs
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.9.4.9]
b. 1782 d. 2 May 1854
11
Asael Smith
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.9.5]
b. 7 Mar 1744 d. 31 Oct 1830
Mary Elizabeth Duty
b. 11 Oct 1743 d. 27 May 1836
12
Jesse Smith
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.9.5.1]
b. 20 Apr 1768 d. 16 Mar 1793 [
=>
]
12
Priscilla Smith
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.9.5.2]
b. 21 Oct 1769 d. 17 Apr 1860 [
=>
]
12
Joseph Smith
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.9.5.3]
b. 12 Jul 1771 d. 14 Sep 1840 [
=>
]
12
Asahel Smith
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.9.5.4]
b. 21 May 1773 d. 21 Jul 1848 [
=>
]
12
Mary Smith
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.9.5.5]
b. 4 Jun 1775 d. 24 May 1844 [
=>
]
12
Samuel Smith
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.9.5.6]
b. 15 Sep 1777 d. 1 Apr 1830 [
=>
]
12
Silas Sanford Smith
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.9.5.7]
b. 1 Oct 1779 d. 13 Sep 1839 [
=>
]
12
Patriarch John Smith
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.9.5.8]
b. 16 Jul 1781 d. 23 May 1854 [
=>
]
12
Susannah Smith
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.9.5.9]
b. 18 May 1783 d. 22 Mar 1849
12
Stephen Smith
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.9.5.10]
b. 23 Apr 1785 d. 25 Jul 1802
12
Sarah Smith
[1.1.2.1.1.4.1.5.5.9.5.11]
b. 16 May 1789 d. 27 May 1824 [
=>
]
9
Priscilla Gould
[1.1.2.1.1.4.1.5.6]
b. 2 Nov 1674 d. 16 Jun 1715
9
Captain Joseph Gould
[1.1.2.1.1.4.1.5.7]
b. 24 Aug 1677 d. 4 Apr 1753
9
Mary Gould
[1.1.2.1.1.4.1.5.8]
b. 16 Jun 1681 d. 11 May 1689
7
Anne Deacon
[1.1.2.1.1.4.2]
b. 22 Jun 1600 d. 22 Oct 1619
+
Richard Paine
b. 20 Feb 1596 bur. 18 May 1645
7
Thomas Deacon
[1.1.2.1.1.4.3]
b. 14 Feb 1602 d. Abt 1608
7
Elisha Deacon
[1.1.2.1.1.4.4]
b. 9 Jan 1603 d. 24 Oct 1658
+
Nancy
c. Abt 1608
7
Sarah Deacon
[1.1.2.1.1.4.5]
b. 25 Dec 1604
7
Martha Deacon
[1.1.2.1.1.4.6]
b. 22 Aug 1613
7
Daughter Deacon
[1.1.2.1.1.4.7]
b. 23 Oct 1619 d. Oct 1619
7
Son Deacon
[1.1.2.1.1.4.8]
b. 23 Oct 1619 d. 23 Oct 1619
5
Audrie Deacon
[1.1.2.1.2]
b. 1552 d. Bef 1582
5
Marie Deacon
[1.1.2.1.3]
b. Abt 1556
5
Roger Deacon
[1.1.2.1.4]
b. Abt 1563 bur. Dec 1616
2
Sir John Spencer
[1.2]
b. Abt 1462 d. Bef 4 Feb 1531
Isabella Graunt
b. 1462 d. 1530
3
Elizabeth Isabel Spencer
[1.2.1]
b. 1486 d. 25 Aug 1560
Nicholas William Strelley
b. 1480 d. 25 Aug 1560
4
John Strelley
[1.2.1.1]
b. 1508 d. 29 Aug 1559
Alice Addington
b. Abt 1515 d. 11 May 1543
5
Frances Strelley
[1.2.1.1.1]
b. Abt 1536 d. Aft 1606
5
Millicent Strelley
[1.2.1.1.2]
b. Dec 1538 d. 2 Jun 1606
Anthony Woolhouse
b. Abt 1534 d. Abt 1587
6
Ann Woolhouse
[1.2.1.1.2.1]
b. Abt 1560 d. Abt 17 Sep 1617
6
Elizabeth Woolhouse
[1.2.1.1.2.2]
b. 1562 d. 10 Mar 1622
Richard Bernard
b. 1578 d. 22 Apr 1613
7
Alice Bernard
[1.2.1.1.2.2.1]
b. 15 Oct 1607
7
Richard Bernard, Jr
[1.2.1.1.2.2.2]
b. 12 Mar 1609 d. 3 Apr 1651
+
Dorothy Alwey
b. 1608 d. 25 Nov 1634
Anna Cordray
b. 29 Apr 1609 d. Apr 1670
8
Anne Cordray Bernard
[1.2.1.1.2.2.2.1]
b. 1 Jan 1634 d. 14 Apr 1698
8
Elizabeth Bernard
[1.2.1.1.2.2.2.2]
b. Abt 1635
8
Richard Bernard, III
[1.2.1.1.2.2.2.3]
b. 1636 d. 1691
Margaret
b. 1640 d. 1709
9
Philip Bernard
[1.2.1.1.2.2.2.3.1]
b. Abt 1659 d. Bef 1709
9
William Bernard
[1.2.1.1.2.2.2.3.2]
c. 24 Oct 1670 d. Bef 27 Apr 1704
Frances Buckner
b. 1682 d. Abt 1743
10
Robert Bernard
[1.2.1.1.2.2.2.3.2.1]
b. Abt 1703 d. Bef 4 Oct 1742
Elizabeth Linch
b. 1705 d. 27 Jan 1750
11
Robert Bernard
[1.2.1.1.2.2.2.3.2.1.1]
b. 1730
11
Elizabeth Bernard
[1.2.1.1.2.2.2.3.2.1.2]
b. Abt 1740
9
Samuel Bernard
[1.2.1.1.2.2.2.3.3]
b. Abt 1672
8
Cordray Bernard
[1.2.1.1.2.2.2.4]
b. 1641
7
John Bernard
[1.2.1.1.2.2.3]
b. 30 Sep 1612
6
Mary Woolhouse
[1.2.1.1.2.3]
b. 1570 d. 1630
Francis Bernard, Jr
b. 1558 d. 21 Nov 1630
7
Ann Bernard
[1.2.1.1.2.3.1]
b. Abt 1600
7
Sir Robert Bernard, 1st Baronet
[1.2.1.1.2.3.2]
b. 1601 d. 18 Apr 1666
7
John Bernard
[1.2.1.1.2.3.3]
b. Abt 1602
7
Colonel William Bernard
[1.2.1.1.2.3.4]
b. Sep 1603 d. 31 Mar 1665
7
James Bernard
[1.2.1.1.2.3.5]
b. Abt 1605
7
Elizabeth Bernard
[1.2.1.1.2.3.6]
b. Abt 1608
7
Margaret Bernard
[1.2.1.1.2.3.7]
b. 1619 d. 1685
Captain Daniel Gaines
b. 1623 d. 1 Oct 1684
8
Bernard Gaines
[1.2.1.1.2.3.7.1]
b. 1651 d. 18 Nov 1747
8
Mary Elizabeth Gaines
[1.2.1.1.2.3.7.2]
b. Abt 1652 d. Bef 1724
Colonel John Catlett, Jr
b. 23 May 1658 d. 19 Jan 1724
9
John Catlett, III
[1.2.1.1.2.3.7.2.1]
b. 4 Apr 1691 d. 3 Jun 1739
9
Mary Catlett
[1.2.1.1.2.3.7.2.2]
b. 1692 d. Nov 1771
9
Margaret Catlett
[1.2.1.1.2.3.7.2.3]
b. 1700 d. 16 Feb 1761
9
Rebecca Catlett
[1.2.1.1.2.3.7.2.4]
b. 27 Dec 1702 d. 6 Mar 1760
Francis Conway
b. 15 Apr 1696 d. 12 Apr 1733
10
Catlett Conway
[1.2.1.1.2.3.7.2.4.1]
b. 11 Jan 1719
10
George Conway
[1.2.1.1.2.3.7.2.4.2]
b. 1720 d. 1754
10
Francis Conway
[1.2.1.1.2.3.7.2.4.3]
b. 27 Dec 1722 d. 17 May 1761
10
Reuben Conway
[1.2.1.1.2.3.7.2.4.4]
b. Nov 1725
10
Sarah Conway
[1.2.1.1.2.3.7.2.4.5]
b. 27 Aug 1727 d. 1800
10
Jane Conway
[1.2.1.1.2.3.7.2.4.6]
b. 22 Dec 1729
10
Eleanor Rose Conway
[1.2.1.1.2.3.7.2.4.7]
b. 9 Jan 1731 d. 11 Feb 1829
Colonel James Madison
b. 27 Mar 1723 d. 27 Feb 1801
11
President James Madison, Jr
[1.2.1.1.2.3.7.2.4.7.1]
b. 16 Mar 1751 d. 28 Jun 1836
+
Dolley Payne
b. 20 May 1768 d. 12 Jul 1849
11
Francis Taylor Madison
[1.2.1.1.2.3.7.2.4.7.2]
b. 18 Jun 1753 d. 5 Apr 1800
11
Major Ambrose Madison
[1.2.1.1.2.3.7.2.4.7.3]
b. 22 Jan 1755 d. 3 Oct 1793
11
Catlett Madison
[1.2.1.1.2.3.7.2.4.7.4]
b. 10 Feb 1758 d. 18 Mar 1758
11
Eleanor Conway Madison
[1.2.1.1.2.3.7.2.4.7.5]
b. 14 Feb 1760 d. 24 Dec 1802
11
General William Taylor Madison
[1.2.1.1.2.3.7.2.4.7.6]
b. 5 May 1762 d. 20 Jul 1843
11
Sarah Catlett Madison
[1.2.1.1.2.3.7.2.4.7.7]
b. 17 Aug 1764 d. 17 Oct 1843
11
Son Madison
[1.2.1.1.2.3.7.2.4.7.8]
b. 12 Jan 1766 d. 13 Jan 1766
11
Elizabeth Madison
[1.2.1.1.2.3.7.2.4.7.9]
b. 6 Feb 1768 d. 17 May 1775
11
Son Madison
[1.2.1.1.2.3.7.2.4.7.10]
b. 12 Jul 1770 d. 12 Jul 1770
11
Reuben Madison
[1.2.1.1.2.3.7.2.4.7.11]
b. 19 Sep 1771 d. 17 May 1775
11
Frances Taylor Madison
[1.2.1.1.2.3.7.2.4.7.12]
b. 4 Oct 1774 d. 4 Oct 1823
9
Elizabeth Catlett
[1.2.1.1.2.3.7.2.5]
b. 6 Sep 1708 d. 27 Aug 1763
8
Margaret Gaines
[1.2.1.1.2.3.7.3]
b. Abt 1653 d. Abt 1719
4
Sir Anthony Strelley
[1.2.1.2]
b. 1512 d. Abt 1569
4
Nicholas Strelley
[1.2.1.3]
b. Abt 1514 d. 26 Oct 1602
4
Isabel Margaret Strelley
[1.2.1.4]
b. Abt 1526
4
Alice Strelley
[1.2.1.5]
b. 1526 d. 4 Feb 1590
4
Jane Strelley
[1.2.1.6]
b. Abt 1532
4
Henry Strelley
[1.2.1.7]
b. Abt 1536
3
Leonard Spencer
[1.2.2]
b. 1494 d. 1568
3
Sir William Spencer
[1.2.3]
b. 1496 d. 22 Jun 1532
3
Anthony Spencer
[1.2.4]
b. 1498 d. 1499
3
Dorothy Spencer
[1.2.5]
b. 1504 d. 8 Mar 1553
3
Elizabeth Spencer
[1.2.6]
b. 1507 d. 25 Aug 1560
John Griffin
b. 1502 bur. 31 Oct 1556
4
Alicia Griffin
[1.2.6.1]
b. 1538 d. 1611
William Jenckes
b. 1536 d. 22 Jun 1636
5
John Jenckes
[1.2.6.1.1]
c. 1556 d. Abt 16 Aug 1625
Sarah Fulwater
b. 19 Mar 1573 d. 1605
6
Sarah Jenckes
[1.2.6.1.1.1]
b. 6 Feb 1596
6
Joseph Jenckes
[1.2.6.1.1.2]
b. 26 Aug 1599 d. 16 Mar 1683
Joan Hearne
b. Abt 1607 d. 28 Feb 1634
7
Joseph Jenckes, Jr
[1.2.6.1.1.2.1]
b. 12 Oct 1632 d. 4 Jan 1717
Esther Ballard
b. 28 Oct 1632 d. 1695
8
Governor Joseph Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.1]
b. 1656 d. 15 Jun 1740
Martha Browne
b. 2 May 1658 d. Abt 1723
9
Captain Joseph Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.1.1]
b. Abt 1682
9
Obadiah Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.1.2]
b. 1684 d. 26 Sep 1758
Alice Eddy
b. 5 Jan 1694 d. Bef 1737
10
Martha Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.1.2.1]
b. Abt 1713
Daniel Hopkins
b. Abt 1707
11
Amy Hopkins
[1.2.6.1.1.2.1.1.2.1.1]
b. Abt 1742 d. 1782
Emor Olney
b. 28 Nov 1741 d. 29 Mar 1830
12
James Olney
[1.2.6.1.1.2.1.1.2.1.1.1]
b. 1761 d. 15 Oct 1840
12
Mary Olney
[1.2.6.1.1.2.1.1.2.1.1.2]
b. 1764 d. 1765
12
Esek Olney
[1.2.6.1.1.2.1.1.2.1.1.3]
b. 6 Nov 1765 d. 1854
12
Emor Olney
[1.2.6.1.1.2.1.1.2.1.1.4]
b. 16 Nov 1765 d. 25 Nov 1852
12
Asa Olney
[1.2.6.1.1.2.1.1.2.1.1.5]
b. 1768 d. 3 Oct 1821 [
=>
]
12
Paris Olney
[1.2.6.1.1.2.1.1.2.1.1.6]
b. 18 Oct 1770 d. 30 Nov 1850
12
Anthony Olney
[1.2.6.1.1.2.1.1.2.1.1.7]
b. 1772 d. 1777
12
Amey Olney
[1.2.6.1.1.2.1.1.2.1.1.8]
b. 1774 d. 1777
12
Hopkins Olney
[1.2.6.1.1.2.1.1.2.1.1.9]
b. 1776 d. 1777
12
Mary Olney
[1.2.6.1.1.2.1.1.2.1.1.10]
b. 1778 d. 1785
12
Rhoda Olney
[1.2.6.1.1.2.1.1.2.1.1.11]
b. 18 Aug 1780 d. 29 Apr 1847
12
Hopkins Olney
[1.2.6.1.1.2.1.1.2.1.1.12]
b. 1782 d. 31 May 1819
10
Obediah Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.1.2.2]
b. Abt 1720 d. 13 Sep 1750
9
Captain Nathaniel Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.1.3]
b. 1686 d. 8 Jun 1753
9
Martha Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.1.4]
b. Abt 1689 d. 22 Dec 1756
9
Mary Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.1.5]
b. 1692 d. 22 Dec 1756
9
Catherine Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.1.6]
b. 1694 d. 1792
William Turpin
b. 1684 d. 15 Mar 1744
10
John Turpin
[1.2.6.1.1.2.1.1.6.1]
b. 1713 d. 1775
10
Elizabeth Allen Turpin
[1.2.6.1.1.2.1.1.6.2]
b. 1715 d. 13 Jan 1791
10
William Turpin
[1.2.6.1.1.2.1.1.6.3]
b. 1716 d. 27 Apr 1736
10
Martha Turpin
[1.2.6.1.1.2.1.1.6.4]
b. 1718 d. 30 Aug 1785
10
Catherine Turpin
[1.2.6.1.1.2.1.1.6.5]
b. 25 Oct 1719 d. 30 Dec 1749
Captain John Hopkins
b. Abt 1713 d. 1 Feb 1741
11
Ruth Hopkins
[1.2.6.1.1.2.1.1.6.5.1]
b. 1737 d. 2 Mar 1822
+
Andrew Aldrich
b. 9 Sep 1737
11
Sarah Hopkins
[1.2.6.1.1.2.1.1.6.5.2]
b. 26 Sep 1739 d. 14 Oct 1818
Commodore Abraham Whipple
b. 26 Sep 1732 d. 27 May 1819
12
Catherine Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.1.6.5.2.1]
b. Abt 1762 d. 1834 [
=>
]
12
Captain John Hopkins Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.1.6.5.2.2]
b. 2 Jul 1765
12
Mary Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.1.6.5.2.3]
b. Abt 1767 d. 15 Aug 1831 [
=>
]
11
Anna Hopkins
[1.2.6.1.1.2.1.1.6.5.3]
b. Abt 1740 d. 26 Dec 1823
William Metcalf
b. 1736 d. 6 Jan 1765
12
Lydia Metcalf
[1.2.6.1.1.2.1.1.6.5.3.1]
b. 1762
Esek Esten
b. 1738
12
John Esten
[1.2.6.1.1.2.1.1.6.5.3.2]
b. 24 Apr 1775 d. 7 Jul 1782
12
Rebecca Esten
[1.2.6.1.1.2.1.1.6.5.3.3]
b. 12 Nov 1776 d. 30 Nov 1856
12
Esek Esten
[1.2.6.1.1.2.1.1.6.5.3.4]
b. 27 Dec 1778 d. 11 Jan 1779
12
Esek Esten
[1.2.6.1.1.2.1.1.6.5.3.5]
b. 14 Dec 1779 d. 21 May 1842
12
Daughter Esten
[1.2.6.1.1.2.1.1.6.5.3.6]
b. 9 Nov 1781 d. 1 Dec 1781
12
Henry Esten
[1.2.6.1.1.2.1.1.6.5.3.7]
b. 22 Oct 1782 d. 12 Nov 1801
12
Catherine Esten
[1.2.6.1.1.2.1.1.6.5.3.8]
b. 8 Jul 1784 d. Jan 1846
12
John Esten
[1.2.6.1.1.2.1.1.6.5.3.9]
b. 21 May 1786 d. 11 Jun
10
Esther Turpin
[1.2.6.1.1.2.1.1.6.6]
b. 1725
10
Anne Turpin
[1.2.6.1.1.2.1.1.6.7]
b. 20 Mar 1725 d. 25 Jan 1753
10
Lydia Turpin
[1.2.6.1.1.2.1.1.6.8]
b. Abt 1727
10
Joseph Turpen
[1.2.6.1.1.2.1.1.6.9]
b. 4 Feb 1729 d. 4 Jul 1784
10
Mary Turpin
[1.2.6.1.1.2.1.1.6.10]
b. Abt 1730 d. Aft 1772
9
John Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.1.7]
b. 6 Apr 1697 d. 17 Jun 1764
9
Lydia Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.1.8]
b. Abt 1704 d. Abt 1774
9
Esther Jencks
[1.2.6.1.1.2.1.1.9]
b. Abt 1706
+
Alice Smith
b. 1665 d. 19 Feb 1736
8
Elizabeth Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.2]
b. 1658 d. 12 May 1740
Samuel Tefft
b. 1643 d. 20 Dec 1725
9
Sarah Tefft
[1.2.6.1.1.2.1.2.1]
b. 1674 bur. 1720
9
Peter Tefft
[1.2.6.1.1.2.1.2.2]
b. 19 Feb 1678 d. 1725
9
Esther Tefft
[1.2.6.1.1.2.1.2.3]
b. Abt 1679 d. Abt 1726
9
Joseph Tefft
[1.2.6.1.1.2.1.2.4]
b. Abt 1680 d. Abt 1767
9
Mary Tefft
[1.2.6.1.1.2.1.2.5]
b. Abt 1683 d. Aft 1721
9
Samuel Tefft, Jr
[1.2.6.1.1.2.1.2.6]
b. Abt 1685 d. 14 Jul 1760
9
Susannah Tefft
[1.2.6.1.1.2.1.2.7]
b. 28 Aug 1685 d. 1737
9
Elizabeth Tefft
[1.2.6.1.1.2.1.2.8]
b. 29 Sep 1687 d. Abt 1750
8
Sarah Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.3]
b. 1660 d. 14 May 1707
Nathanial Brown
b. 9 Jun 1661 d. 13 Nov 1739
9
Esther Brown
[1.2.6.1.1.2.1.3.1]
b. 25 Mar 1688 d. 27 Oct 1779
9
Peter Brown
[1.2.6.1.1.2.1.3.2]
b. 25 Mar 1688
9
Nathaniel Brown
[1.2.6.1.1.2.1.3.3]
b. 24 Sep 1689 d. 29 Jul 1749
9
Nathan Brown
[1.2.6.1.1.2.1.3.4]
b. 19 Sep 1691 d. 3 Jul 1737
9
John Bown
[1.2.6.1.1.2.1.3.5]
b. 30 Mar 1694 d. 14 Oct 1753
9
Joseph Brown
[1.2.6.1.1.2.1.3.6]
b. 18 Sep 1695 d. 14 Apr 1724
9
Elizabeth Brown
[1.2.6.1.1.2.1.3.7]
b. Mar 1696
9
Sarah Brown
[1.2.6.1.1.2.1.3.8]
b. 19 Feb 1698 d. 1763
9
Penelope Brown
[1.2.6.1.1.2.1.3.9]
b. 17 May 1699 d. 10 Jul 1759
9
Elizabeth Brown
[1.2.6.1.1.2.1.3.10]
b. Abt 1700 d. 25 Jul 1761
9
Mary Brown
[1.2.6.1.1.2.1.3.11]
b. 18 Jan 1702 d. Abt 1728
9
Kesia Brown
[1.2.6.1.1.2.1.3.12]
b. 1704 d. 17 May 1755
9
Elizabeth Brown
[1.2.6.1.1.2.1.3.13]
b. 20 Jun 1706
8
Lemuel Holmes Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.4]
b. 1661
8
Nathaniel Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.5]
b. 29 Jan 1662 d. 11 Aug 1723
Hannah Bosworth
b. 5 Nov 1663 d. 31 Jul 1723
9
Hannah Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.5.1]
b. 1690 d. 1733
9
Jonathan Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.5.2]
b. 6 May 1688
9
Elizabeth Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.5.3]
b. 1 Jan 1698 d. 26 Apr 1768
9
Nathaniel Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.5.4]
b. 4 Jan 1699 d. 13 Dec 1739
8
James Varnum Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.6]
b. 1663
8
Daniel Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.7]
b. 19 Apr 1663 d. 1736
Katherine Balcolm
b. Abt 1664 d. 1729
9
Mary Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.7.1]
b. Abt 1692 d. 22 Apr 1784
Joseph Weatherhead
b. Abt 1688
10
Jeremiah Weatherhead
[1.2.6.1.1.2.1.7.1.1]
b. 22 Jan 1714 d. 14 May 1799
10
Daniel Weatherhead
[1.2.6.1.1.2.1.7.1.2]
b. 25 Aug 1717 d. 16 Jan 1794
Berthia
11
John Weatherhead
[1.2.6.1.1.2.1.7.1.2.1]
b. 27 Dec 1740 d. 28 Jan 1817
Tabatha Kempton
b. Abt 1748 d. 9 Apr 1830
12
Freelove Weatherhead
[1.2.6.1.1.2.1.7.1.2.1.1]
b. 14 Dec 1771 d. 9 Jul 1832
12
Welcome Weatherhead
[1.2.6.1.1.2.1.7.1.2.1.2]
b. 8 Feb 1776
12
Lavinia Weatherhead
[1.2.6.1.1.2.1.7.1.2.1.3]
b. 1 Sep 1778
12
Susanna Weatherhead
[1.2.6.1.1.2.1.7.1.2.1.4]
b. 3 Jan 1781
12
Mary Weatherhead
[1.2.6.1.1.2.1.7.1.2.1.5]
b. 11 Feb 1784
12
Ruth Tabitha Weatherhead
[1.2.6.1.1.2.1.7.1.2.1.6]
b. 9 Mar 1786 d. 6 Dec 1864 [
=>
]
12
Whipple Weatherhead
[1.2.6.1.1.2.1.7.1.2.1.7]
b. 22 Jun 1788 d. 28 Feb 1867
12
John Weatherhead
[1.2.6.1.1.2.1.7.1.2.1.8]
b. 22 Feb 1790 d. 30 Oct 1870
10
Joseph Weatherhead
[1.2.6.1.1.2.1.7.1.3]
b. 22 Apr 1720
10
John Weaatheerhead
[1.2.6.1.1.2.1.7.1.4]
b. 21 Sep 1728
9
Elizabeth Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.7.2]
b. 24 Aug 1694 d. 25 Apr 1768
9
Abigail Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.7.3]
b. 28 Jul 1696 d. Bef 15 Mar 1737
9
Martha Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.7.4]
b. 5 Aug 1698 d. 22 Jun 1751
John Arnold
b. 29 May 1697 d. 12 Mar 1727
10
David Arnold
[1.2.6.1.1.2.1.7.4.1]
b. Abt 1710 d. 1 Feb 1786
Mercy Whipple
b. 15 Mar 1721
11
Elisha Arnold
[1.2.6.1.1.2.1.7.4.1.1]
b. 1754 d. 27 May 1838
11
Stephen Arnold
[1.2.6.1.1.2.1.7.4.1.2]
b. Aft 1756
11
David Arnold
[1.2.6.1.1.2.1.7.4.1.3]
11
Eleazer Aldrich
[1.2.6.1.1.2.1.7.4.1.4]
11
Abigail Arnold
[1.2.6.1.1.2.1.7.4.1.5]
11
Martha Arnold
[1.2.6.1.1.2.1.7.4.1.6]
10
Moses Arnold
[1.2.6.1.1.2.1.7.4.2]
b. 1718
10
Captain Noah Arnold
[1.2.6.1.1.2.1.7.4.3]
b. 1720 d. 1800
10
Daniel Arnold
[1.2.6.1.1.2.1.7.4.4]
b. 1724
10
Aaron Arnold
[1.2.6.1.1.2.1.7.4.5]
b. 1726
9
Susanna Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.7.5]
b. 24 May 1700 d. 18 Mar 1732
9
Daniel Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.7.6]
b. 12 Mar 1702 d. 24 Jan 1789
Mercy Sprague
b. 17 Jun 1703 d. 19 Apr 1749
10
Catherine Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.7.6.1]
b. 23 Mar 1729
10
Jeremiah Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.7.6.2]
b. 12 Feb 1730 d. 17 Feb 1819
10
Hannah Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.7.6.3]
b. 1 Nov 1732 d. 25 Nov 1794
10
John Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.7.6.4]
b. 2 Nov 1734 d. 22 Feb 1818
10
Phebe Jencks
[1.2.6.1.1.2.1.7.6.5]
b. 14 Feb 1735 d. 1828
10
Mercy Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.7.6.6]
b. 2 Sep 1737 d. 18 Feb 1797
10
Mary Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.7.6.7]
b. 2 Sep 1737
10
David Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.7.6.8]
b. 21 Jun 1739 d. 3 Dec 1822
10
Daniel Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.7.6.9]
b. 19 Mar 1743 d. 1801
Sarah Whipple
b. 26 Dec 1741 d. Aft May 1784
11
Gideon Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.7.6.9.1]
b. 31 May 1764 d. 25 Sep 1822
Anna White
b. 9 Apr 1769 d. 15 Oct 1850
12
Daniel Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.7.6.9.1.1]
b. 24 Aug 1788 d. 1846 [
=>
]
12
Isaac Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.7.6.9.1.2]
b. 13 Dec 1790 d. 3 Apr 1851
12
William Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.7.6.9.1.3]
b. 2 Jan 1796
12
Whipple Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.7.6.9.1.4]
b. 2 Nov 1798
12
Susanna Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.7.6.9.1.5]
b. 2 Jun 1803
12
Rhoda Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.7.6.9.1.6]
b. 21 Mar 1808
Rhoda Cruff
b. 9 Feb 1749
11
Lemuel Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.7.6.9.2]
b. 8 Aug 1768
11
Sarah Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.7.6.9.3]
b. 8 Sep 1769
11
Jabez Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.7.6.9.4]
b. 27 May 1784 d. 1805
11
Captain Sterry Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.7.6.9.5]
b. 6 Feb 1787 d. 26 Nov 1853
Anne Nancy Dexter
b. 1782
12
Horatio Nelson Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.7.6.9.5.1]
b. 8 Aug 1810 d. 30 Dec 1828
12
Elcy Ann Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.7.6.9.5.2]
b. 3 Sep 1813 d. 12 Dec 1828
12
Jabez Walcott Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.7.6.9.5.3]
b. 7 Jan 1815 d. 11 Jan 1883
12
Rhoda Ann Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.7.6.9.5.4]
b. 15 Jan 1818 d. 7 Aug 1847 [
=>
]
12
Diana Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.7.6.9.5.5]
b. 7 Apr 1820 d. 4 Mar 1890
12
Albert Cheney Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.7.6.9.5.6]
b. 16 Mar 1822 d. 22 Dec 1887
12
Mary Humphry Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.7.6.9.5.7]
b. 24 Jan 1824 d. 17 Mar 1914
12
Charles Erastus Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.7.6.9.5.8]
b. 10 Oct 1825 d. 7 Apr 1896
12
Ardelia Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.7.6.9.5.9]
b. 9 Sep 1827 d. 8 Sep 1925
12
Henry Hartwell Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.7.6.9.5.10]
b. 14 Aug 1829
12
Nathaniel Miles Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.7.6.9.5.11]
b. 28 Aug 1831 d. 5 Jul 1892
12
George F Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.7.6.9.5.12]
b. 7 May 1834 d. 27 May 1922
10
Mary Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.7.6.10]
b. 3 Jun 1746 d. 15 Mar 1800
9
Hannah Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.7.7]
b. 15 Feb 1704 d. 22 Nov 1723
9
Ruth Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.7.8]
b. 9 Dec 1705
Job Whipple, Jr
b. 1704 d. 25 Feb 1729
10
Ephraim Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.7.8.1]
b. Abt 1727 d. 1805
Sylvia Lapham
b. 8 May 1731 d. 11 May 1805
11
Job Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.7.8.1.1]
b. 30 Mar 1749 d. 18 Sep 1822
Elizabeth Freelove Carpenter
b. 27 Apr 1749 d. 16 Feb 1834
12
Sylvia Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.7.8.1.1.1]
b. 9 Sep 1773 d. 20 Oct 1834 [
=>
]
12
Olive Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.7.8.1.1.2]
b. 9 Feb 1775 d. 11 Jan 1839 [
=>
]
12
David Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.7.8.1.1.3]
b. 30 Jul 1776 d. 9 Jul 1833 [
=>
]
12
Otis Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.7.8.1.1.4]
b. 18 Nov 1777 d. 20 Oct 1863
12
Daniel Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.7.8.1.1.5]
b. 8 Oct 1782 d. 8 Nov 1841 [
=>
]
12
Lydia Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.7.8.1.1.6]
b. 10 Oct 1784 d. 25 Nov 1870 [
=>
]
12
Betsey Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.7.8.1.1.7]
b. 16 Aug 1789 d. 16 Aug 1791
12
Anna Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.7.8.1.1.8]
b. 28 Mar 1791 d. 15 May 1839
12
Elizabeth Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.7.8.1.1.9]
b. 6 Oct 1799
11
David Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.7.8.1.2]
b. Abt 1748 d. Aft 1775
11
Ephriam Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.7.8.1.3]
b. Abt 1753
Zerviah Mason
b. 1 Nov 1753 d. 11 Nov 1784
12
Mason Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.7.8.1.3.1]
b. Abt 1780 d. 1842
11
Daughter Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.7.8.1.4]
b. Abt 1753
Pricilla Appleby
b. Abt 1730
11
Phoebe Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.7.8.1.5]
b. 4 Nov 1755
11
Mary Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.7.8.1.6]
b. 15 Dec 1757
11
Hannah Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.7.8.1.7]
b. 1759
Amaziah Jillson
b. 28 Oct 1750
12
James Jillson
[1.2.6.1.1.2.1.7.8.1.7.1]
b. 1781 [
=>
]
12
Charles Jillson
[1.2.6.1.1.2.1.7.8.1.7.2]
b. 1785
12
Cynthia Jillson
[1.2.6.1.1.2.1.7.8.1.7.3]
b. 1788
12
Phila Jillson
[1.2.6.1.1.2.1.7.8.1.7.4]
b. 1791 [
=>
]
12
David Jillson
[1.2.6.1.1.2.1.7.8.1.7.5]
b. 28 Nov 1793 d. 9 Jun 1841 [
=>
]
12
William D Jillson
[1.2.6.1.1.2.1.7.8.1.7.6]
b. 1797 d. 1854 [
=>
]
12
Otis Jillson
[1.2.6.1.1.2.1.7.8.1.7.7]
b. 1800 d. 7 Jan 1853 [
=>
]
12
Harvey Jillson
[1.2.6.1.1.2.1.7.8.1.7.8]
b. 1802
11
Marmaduke Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.7.8.1.8]
b. 30 Jan 1761 d. 26 Dec 1836
Wealthy Whipple
b. 3 Mar 1764 d. 9 Nov 1867
12
Aretas Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.7.8.1.8.1]
b. 2 Jun 1784
11
Anne Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.7.8.1.9]
b. Abt 1765
+
John Carpenter
b. Abt 1760
11
Barneville "Barney" Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.7.8.1.10]
b. 3 Aug 1769 d. 19 Dec 1846
Anna Ramsdell
b. 1770 d. 1830
12
Barneville Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.7.8.1.10.1]
b. 17 Jul 1791 d. 1 Feb 1868 [
=>
]
12
Ruth Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.7.8.1.10.2]
b. 18 Feb 1794 d. 2 Jun 1855
12
Sarah Ann Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.7.8.1.10.3]
b. 1796 d. 28 May 1863 [
=>
]
12
Annie Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.7.8.1.10.4]
b. 1801
12
Welcome Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.7.8.1.10.5]
b. 1803 d. 9 May 1855
11
Jenckes B Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.7.8.1.11]
b. 3 Aug 1769 d. 19 Dec 1846
9
Joseph Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.7.9]
b. 5 Mar 1708
8
Esther Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.8]
b. 1664 d. 29 Jul 1721
Samuel Millard
b. 5 Oct 1658 d. 31 Aug 1720
9
Joseph Millard
[1.2.6.1.1.2.1.8.1]
b. 28 Jul 1701 d. 2 Feb 1703
9
Joseph Millard
[1.2.6.1.1.2.1.8.2]
b. 17 Feb 1710 d. 27 Jun 1764
Benjamin Bucklin
b. 30 Jan 1697 d. 15 Feb 1739
9
Benjamin Bucklin
[1.2.6.1.1.2.1.8.3]
b. Abt 1727
8
Eliza Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.9]
b. 1665
8
Joanna Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.10]
b. 10 Nov 1672 d. 12 Mar 1756
Sylvanus Scott
b. 10 Nov 1672 d. 13 Jan 1742
9
John Scott
[1.2.6.1.1.2.1.10.1]
b. 30 Sep 1694 d. 11 Jul 1782
Mercy Wilkinson
b. 30 Jun 1694 d. Bef 1765
10
Freelove Scott
[1.2.6.1.1.2.1.10.1.1]
b. 1718
David Razee
b. 18 Mar 1713 d. 25 Aug 1783
11
Freelove Razee
[1.2.6.1.1.2.1.10.1.1.1]
b. 7 Jan 1738
11
Hopestill Razee
[1.2.6.1.1.2.1.10.1.1.2]
b. 15 Jun 1742
11
Sarah Raze
[1.2.6.1.1.2.1.10.1.1.3]
b. 18 Aug 1744
11
Zebiah Razee
[1.2.6.1.1.2.1.10.1.1.4]
b. 13 Oct 1746 d. 1821
10
Hannah Scott
[1.2.6.1.1.2.1.10.1.2]
b. 1719
10
Sarah Scott
[1.2.6.1.1.2.1.10.1.3]
b. 1723
9
Catharine Scott
[1.2.6.1.1.2.1.10.2]
b. 31 Mar 1696
9
Joseph Scott
[1.2.6.1.1.2.1.10.3]
b. 15 Aug 1697 d. 14 Sep 1742
9
Rebecca Scott
[1.2.6.1.1.2.1.10.4]
b. 11 Feb 1699
John Wilkinson, Jr
b. 16 Mar 1690 d. 25 Sep 1756
10
Amy Wilkinson
[1.2.6.1.1.2.1.10.4.1]
b. 23 Jan 1719
10
Anne Wilkinson
[1.2.6.1.1.2.1.10.4.2]
b. 19 May 1721 d. 7 Sep 1722
10
William Wilkinson
[1.2.6.1.1.2.1.10.4.3]
b. 1723 d. 1769
Hulda Godwin
b. 1727
11
John Wilkinson
[1.2.6.1.1.2.1.10.4.3.1]
b. 1744 d. 3 Nov 1787
11
Thomas Wilkinson
[1.2.6.1.1.2.1.10.4.3.2]
b. 1745
11
Hazelwood Wilkinson
[1.2.6.1.1.2.1.10.4.3.3]
b. 1747
11
Amelia Wilkinson
[1.2.6.1.1.2.1.10.4.3.4]
b. 1749
11
Stephen Wilkinson
[1.2.6.1.1.2.1.10.4.3.5]
b. 1751 d. 1786
11
Reuben Wilkinson
[1.2.6.1.1.2.1.10.4.3.6]
b. 1753
11
Benjamin Wilkinson
[1.2.6.1.1.2.1.10.4.3.7]
b. 1756
11
William Wilkinson
[1.2.6.1.1.2.1.10.4.3.8]
b. 1758
10
John Wilkinson
[1.2.6.1.1.2.1.10.4.4]
b. 20 Mar 1724 d. 23 Jun 1804
Ruth Angell
b. Abt 1710
11
Orziel Wilkinson
[1.2.6.1.1.2.1.10.4.4.1]
b. 30 Jan 1744 d. 22 Oct 1815
11
Martha Wilkinson
[1.2.6.1.1.2.1.10.4.4.2]
b. 1746 d. Apr 1820
11
Susanna Wilkinson
[1.2.6.1.1.2.1.10.4.4.3]
b. 1748 d. 15 Jan 1778
10
Benjamin Wilkinson
[1.2.6.1.1.2.1.10.4.5]
b. 1725 d. 1795
10
Sarah Wilkinson
[1.2.6.1.1.2.1.10.4.6]
b. 22 Jun 1727 d. 6 Mar 1761
Amos Arnold
b. 29 Mar 1721 d. 28 Nov 1792
11
Rufus Arnold
[1.2.6.1.1.2.1.10.4.6.1]
b. 8 Feb 1752
11
Lydia Arnold
[1.2.6.1.1.2.1.10.4.6.2]
b. 25 Feb 1754
11
Arnold
[1.2.6.1.1.2.1.10.4.6.3]
b. 10 Sep 1756 d. 26 Sep 1756
11
John Arnold
[1.2.6.1.1.2.1.10.4.6.4]
b. 28 Jan 1758 d. 11 Jun 1758
11
Enoch Arnold
[1.2.6.1.1.2.1.10.4.6.5]
b. 6 Mar 1762
11
Sarah Arnold
[1.2.6.1.1.2.1.10.4.6.6]
b. 6 Mar 1762
10
Susanna Wilkinson
[1.2.6.1.1.2.1.10.4.7]
b. 20 Sep 1729 d. 26 Mar 1803
Joseph Jenckes
b. 1729 d. 14 Nov 1793
11
Nicholas Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.10.4.7.1]
b. Abt 1750 d. Jul 1819
11
David Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.10.4.7.2]
b. Abt 1752 d. 1 Mar 1831
11
George Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.10.4.7.3]
b. Abt 1752
11
Deborah Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.10.4.7.4]
b. Abt 1756 d. 1 Nov 1831
11
Lemuel Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.10.4.7.5]
b. Abt 1756 d. 8 Jul 1845
11
Sarah Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.10.4.7.6]
b. Abt 1758 d. 13 Nov 1845
11
Susannah Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.10.4.7.7]
b. Abt 1768 d. 19 Mar 1800
11
Mary Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.10.4.7.8]
b. Abt 1760
10
Ruth Wilkinson
[1.2.6.1.1.2.1.10.4.8]
b. 5 Mar 1731
10
Joanna Wilkinson
[1.2.6.1.1.2.1.10.4.9]
b. 12 Sep 1732
10
Ahab Wilkinson
[1.2.6.1.1.2.1.10.4.10]
b. 16 Dec 1734
Abigail Scott
b. 1722
11
Simeon Wilkinson
[1.2.6.1.1.2.1.10.4.10.1]
b. 10 Mar 1756 d. 27 Nov 1816
11
John Wilkenson
[1.2.6.1.1.2.1.10.4.10.2]
b. 15 Jun 1757 d. 23 Jun 1826
11
Joseph Wilkinson
[1.2.6.1.1.2.1.10.4.10.3]
b. 7 Oct 1759 d. 25 Sep 1812
11
Sarah Wilkinson
[1.2.6.1.1.2.1.10.4.10.4]
b. 19 Mar 1765
11
George Wilkinson
[1.2.6.1.1.2.1.10.4.10.5]
b. 9 Jan 1767
9
Esther Scott
[1.2.6.1.1.2.1.10.5]
b. 5 Dec 1700 d. 18 Jul 1788
Thomas Sayles
b. 9 Feb 1699 d. 9 Nov 1754
10
John Sayles
[1.2.6.1.1.2.1.10.5.1]
b. 6 Jan 1723 d. 1 Mar 1822
10
Captain Sylvanus Sayles
[1.2.6.1.1.2.1.10.5.2]
b. 29 Mar 1724 d. 31 Dec 1809
10
Stephen Sayles
[1.2.6.1.1.2.1.10.5.3]
b. 16 Jul 1727 d. 10 Mar 1819
10
Joseph Sayles
[1.2.6.1.1.2.1.10.5.4]
b. 29 Sep 1730 d. Bef 1830
10
Thomas Sayles
[1.2.6.1.1.2.1.10.5.5]
b. 21 Jun 1733
10
Martha Sayles
[1.2.6.1.1.2.1.10.5.6]
b. 5 Aug 1735 d. 18 Nov 1737
10
Esther Sayles
[1.2.6.1.1.2.1.10.5.7]
b. 7 Jan 1738 d. 27 Sep 1829
James Appleby
b. 1710 d. 25 Sep 1798
11
Hannah Appelby
[1.2.6.1.1.2.1.10.5.7.1]
b. 12 Jun 1758
11
Thomas Applebey
[1.2.6.1.1.2.1.10.5.7.2]
b. 10 Mar 1760 d. 26 Jul 1826
11
Martha Appeleby
[1.2.6.1.1.2.1.10.5.7.3]
b. 8 Jan 1762 d. 5 Aug 1820
11
Phebe Appleby
[1.2.6.1.1.2.1.10.5.7.4]
b. 30 Sep 1763 d. 26 May 1824
11
Elizabeth Appleby
[1.2.6.1.1.2.1.10.5.7.5]
b. 21 Aug 1765 d. 19 Jan 1814
11
Stephen Appleby
[1.2.6.1.1.2.1.10.5.7.6]
b. Abt 1767 d. 27 Dec 1836
+
Anna Olney
b. 29 Aug 1769 d. 1854
11
Esther Appleby
[1.2.6.1.1.2.1.10.5.7.7]
b. 27 Jul 1770 d. Aug 1790
11
James Appleby
[1.2.6.1.1.2.1.10.5.7.8]
b. 3 May 1773 d. 9 Jun 1828
11
Appleby
[1.2.6.1.1.2.1.10.5.7.9]
b. 10 May 1775 d. 9 Apr 1776
11
Charles Appleby
[1.2.6.1.1.2.1.10.5.7.10]
b. 10 Mar 1779 d. 17 Sep 1854
Esther Olney
b. 1774
12
Thomas S Appleby
[1.2.6.1.1.2.1.10.5.7.10.1]
b. Abt 1808 [
=>
]
12
Silas Smith Appleby
[1.2.6.1.1.2.1.10.5.7.10.2]
b. Abt 1808 [
=>
]
12
Esther L Appleby
[1.2.6.1.1.2.1.10.5.7.10.3]
b. Abt 1815
12
George M Appleby
[1.2.6.1.1.2.1.10.5.7.10.4]
b. Abt 1815
10
Elisabeth Sayles
[1.2.6.1.1.2.1.10.5.8]
b. 15 Oct 1740 d. 12 Dec 1820
10
Nathan Sayles
[1.2.6.1.1.2.1.10.5.9]
b. 21 Apr 1741
10
Jeremiah Sayles
[1.2.6.1.1.2.1.10.5.10]
b. 17 Dec 1743 d. 27 Jun 1816
Anne Steere
b. 21 Jan 1753 d. 16 Jul 1835
11
Martha Sayles
[1.2.6.1.1.2.1.10.5.10.1]
b. 11 Jun 1776 d. 1852
11
James Sayles
[1.2.6.1.1.2.1.10.5.10.2]
b. 11 Oct 1777 d. 27 Jan 1793
11
Abigail Sayles
[1.2.6.1.1.2.1.10.5.10.3]
b. 18 Aug 1788 d. 11 Mar 1860
11
Stephen Sayles
[1.2.6.1.1.2.1.10.5.10.4]
b. 3 Sep 1791 d. 27 Dec 1823
9
Sylvanus Scott
[1.2.6.1.1.2.1.10.6]
b. 20 Jun 1702 d. 20 Apr 1777
Mary
b. Abt 1705
10
Ichabod Scott
[1.2.6.1.1.2.1.10.6.1]
b. Abt 1721
10
Sylvanus Scott, Jr
[1.2.6.1.1.2.1.10.6.2]
b. Abt 1723
10
David Scott
[1.2.6.1.1.2.1.10.6.3]
b. Abt 1725
10
Sarah Scott
[1.2.6.1.1.2.1.10.6.4]
b. Abt 1727
10
Joanna Scott
[1.2.6.1.1.2.1.10.6.5]
b. Abt 1729
10
Charles Scott
[1.2.6.1.1.2.1.10.6.6]
b. Abt 1731
10
John Scott
[1.2.6.1.1.2.1.10.6.7]
b. Abt 1733
+
Joanna Cushman
b. 17 Dec 1713 d. 26 Apr 1777
9
Jeanna Scott
[1.2.6.1.1.2.1.10.7]
b. 11 Dec 1703 d. 13 Mar 1796
9
Charles Scott
[1.2.6.1.1.2.1.10.8]
b. 23 Aug 1705 d. 13 May 1745
+
Abigail Olney
b. 23 Feb 1705 d. 28 Oct 1739
Freelove Olney
b. 29 Nov 1711 d. Aft 1730
10
Jermiah Scott
[1.2.6.1.1.2.1.10.8.1]
b. 1730 d. 1795
9
Sarah Scott
[1.2.6.1.1.2.1.10.9]
b. 15 Jun 1707
9
Jeremiah Scott
[1.2.6.1.1.2.1.10.10]
b. 11 Mar 1709
9
Nathanael Scott
[1.2.6.1.1.2.1.10.11]
b. 19 Apr 1711 d. 15 Mar 1744
8
Mary Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.11]
b. Abt 1666
8
George Foster Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.12]
b. Abt 1667 d. 2 Jun 1882
8
Reverand Ebenezer Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.13]
b. 17 Sep 1669 d. 14 Aug 1726
Mary Butterworth
b. 20 Oct 1677 d. 14 Aug 1726
9
Sarah Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.13.1]
b. 26 Dec 1695 d. 3 May 1735
9
Judge Ebenezer Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.13.2]
b. 17 Sep 1699 bur. Aft 27 Nov 1786
Experience Martin
b. 3 Sep 1706 d. 22 Jul 1798
10
Nathan Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.13.2.1]
b. Abt 1727 d. 4 Sep 1760
10
Ichabod Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.13.2.2]
b. Abt 1727
10
Phebe Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.13.2.3]
b. 1729 d. Aft 21 Mar 1776
William Jenckes
b. 1750
11
Ruth Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.13.2.3.1]
b. 29 Feb 1768 d. 1850
Charles Chase
b. 25 Oct 1762 d. 1850
12
Alanson Chase
[1.2.6.1.1.2.1.13.2.3.1.1]
b. 22 Oct 1795 d. 13 Feb 1875 [
=>
]
12
Charles Chase
[1.2.6.1.1.2.1.13.2.3.1.2]
b. 21 Jun 1797 d. 19 Jan 1894
12
Diana Chase
[1.2.6.1.1.2.1.13.2.3.1.3]
b. 28 Aug 1799 d. 24 Aug 1873
12
William J Chase
[1.2.6.1.1.2.1.13.2.3.1.4]
b. Abt Sep 1805 d. 23 May 1806
12
George Ide Chase
[1.2.6.1.1.2.1.13.2.3.1.5]
b. 19 Feb 1808 d. 29 Apr 1885
12
Amy Ann Chase
[1.2.6.1.1.2.1.13.2.3.1.6]
b. 7 Nov 1810
11
Job Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.13.2.3.2]
b. 21 Mar 1770 d. 11 Aug 1835
Sarah Aldrich
b. 5 Sep 1778 d. 1 Nov 1836
12
Rosina Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.13.2.3.2.1]
b. 3 Jun 1795 d. 20 Sep 1865 [
=>
]
12
Nelson J Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.13.2.3.2.2]
b. 22 Jul 1797 d. 23 Jan 1855 [
=>
]
12
George Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.13.2.3.2.3]
b. 15 Jun 1799 d. 12 Dec 1869 [
=>
]
12
Wheaton Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.13.2.3.2.4]
b. 26 Sep 1801 d. 4 Sep 1803
12
Barton J Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.13.2.3.2.5]
b. 8 Jan 1804 d. 16 Jun 1834 [
=>
]
12
Charles Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.13.2.3.2.6]
b. 28 Jul 1806 d. 30 Aug 1861 [
=>
]
12
Albert Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.13.2.3.2.7]
b. 13 Feb 1809 [
=>
]
12
Mary Ann Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.13.2.3.2.8]
b. 2 Jul 1811 d. 24 Nov 1836
12
Julia E Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.13.2.3.2.9]
b. 31 Jul 1813 d. 31 Dec 1872 [
=>
]
12
William Augustus Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.13.2.3.2.10]
b. 12 Jun 1815 d. 19 Aug 1899 [
=>
]
12
Harriet Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.13.2.3.2.11]
b. 5 Aug 1819 d. 29 Sep 1820
12
Horace Aldrich Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.13.2.3.2.12]
b. 8 Apr 1822 d. 24 Apr 1840
12
Edwin Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.13.2.3.2.13]
b. 9 Jan 1826 d. 12 Jun 1895 [
=>
]
11
Mary Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.13.2.3.3]
b. 24 Nov 1772 d. 4 Jan 1818
11
Luke Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.13.2.3.4]
b. 1774 d. 13 Oct 1848
Robey Arnold
b. 2 Oct 1778 d. 22 Aug 1875
12
Lydia Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.13.2.3.4.1]
b. 1800 d. 21 Jul 1876
12
Luke Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.13.2.3.4.2]
b. 1803 d. 15 Mar 1843 [
=>
]
11
Diana Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.13.2.3.5]
b. 1 Jan 1776 d. 11 Aug 1847
10
Freelove Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.13.2.4]
b. Abt 1731 d. 22 Apr 1818
10
Hopestill Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.13.2.5]
b. Abt 1733 d. 1781
10
Mary Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.13.2.6]
b. Abt 1740 d. 4 Mar 1818
10
Susanna Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.13.2.7]
b. 6 Jun 1740 d. 23 Apr 1833
9
Rufus Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.13.3]
b. 18 Dec 1704
9
Rachael Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.13.4]
b. 1 Dec 1706 d. 17 Jan 1777
9
Joseph Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.13.5]
b. 25 Jan 1711 d. 25 May 1784
9
Mercy Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.13.6]
b. 26 Aug 1712 d. 9 Mar 1758
9
Benjamin Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.13.7]
b. 3 Nov 1714
9
Noah Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.13.8]
b. 13 Sep 1717
9
Freelove Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.13.9]
b. 13 Sep 1717
9
Josiah Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.13.10]
b. 2 Apr 1720 d. Abt 1744
8
Albert Carlisle Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.14]
b. Abt 1671 d. 1708
8
William Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.15]
b. 1674 d. 2 Oct 1765
Patience Sprague
b. 1674 d. 29 Aug 1770
9
William Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.15.1]
b. 1700 d. 19 Jul 1765
Amphilis Smith
b. 1704 d. 29 Aug 1770
10
William Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.15.1.1]
b. 1724 d. 5 Nov 1815
Ester Tingley
b. Abt 1730 d. 1767
11
Isabel Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.15.1.1.1]
b. Abt 1750
+
Joseph Hale
b. 1746
11
William Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.15.1.1.2]
b. 1750
Phebe Jenckes
b. 1729 d. Aft 21 Mar 1776
12
Ruth Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.15.1.1.2.1]
b. 29 Feb 1768 d. 1850 [
=>
]
12
Job Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.15.1.1.2.2]
b. 21 Mar 1770 d. 11 Aug 1835 [
=>
]
12
Mary Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.15.1.1.2.3]
b. 24 Nov 1772 d. 4 Jan 1818
12
Luke Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.15.1.1.2.4]
b. 1774 d. 13 Oct 1848 [
=>
]
12
Diana Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.15.1.1.2.5]
b. 1 Jan 1776 d. 11 Aug 1847
10
Lydia Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.15.1.2]
b. 1734 d. 15 Nov 1800
10
Christopher Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.15.1.3]
b. 1725 d. 22 Nov 1825
Hannah Whipple
b. 2 May 1735 d. 22 Nov 1825
11
Lydia Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.15.1.3.1]
b. 8 Dec 1752
John Mathewson
b. 7 Jun 1746 d. 1835
12
Peregrin Mathewson
[1.2.6.1.1.2.1.15.1.3.1.1]
b. 17 Jan 1775 [
=>
]
12
Welcome Mathewson
[1.2.6.1.1.2.1.15.1.3.1.2]
b. 15 Aug 1778 d. 1872 [
=>
]
12
Hannah Mathewson
[1.2.6.1.1.2.1.15.1.3.1.3]
b. 18 Apr 1781
12
John Mathewson
[1.2.6.1.1.2.1.15.1.3.1.4]
b. 1 Jan 1785
12
Lydia Mathewson
[1.2.6.1.1.2.1.15.1.3.1.5]
b. 18 Apr 1787
12
Anphillis Mathewson
[1.2.6.1.1.2.1.15.1.3.1.6]
b. 4 Mar 1790
12
Amey Mathewson
[1.2.6.1.1.2.1.15.1.3.1.7]
b. 3 Feb 1795
11
Joshua Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.15.1.3.2]
b. 15 Jan 1754 d. Jun 1807
Susannah Whipple
b. 11 Jul 1762 d. 1 Feb 1832
12
Salinda Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.15.1.3.2.1]
b. 21 Feb 1799 d. 2 Feb 1856
12
Anphillas Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.15.1.3.2.2]
b. 25 Sep 1800
12
Parley Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.15.1.3.2.3]
b. 31 Jan 1802 d. 28 Mar 1866
12
Hannah Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.15.1.3.2.4]
b. 1 Jul 1803 d. 1852
12
Lemuel Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.15.1.3.2.5]
b. Abt 1805 d. 10 Jul 1845
11
Hannah Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.15.1.3.3]
b. 21 Jul 1756
11
Anphillis Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.15.1.3.4]
b. 20 Feb 1757
11
Christopher Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.15.1.3.5]
b. 17 May 1760
11
Adam Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.15.1.3.6]
b. 7 Nov 1762 d. Aft 1835
11
Elizabeth Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.15.1.3.7]
b. 11 Feb 1764
11
Amie Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.15.1.3.8]
b. 21 Sep 1770
11
General Charles Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.15.1.3.9]
b. 7 Aug 1767 d. 4 Jul 1838
Rachel Benson
b. 5 May 1777 d. 21 Nov 1842
12
Charles Benson Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.15.1.3.9.1]
b. 10 Apr 1796 d. Aft 1831 [
=>
]
10
Martha Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.15.1.4]
b. 22 Jan 1725 d. Jun 1826
10
Joseph Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.15.1.5]
b. 1729 d. 14 Nov 1793
Susanna Wilkinson
b. 20 Sep 1729 d. 26 Mar 1803
11
Nicholas Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.15.1.5.1]
b. Abt 1750 d. Jul 1819
11
David Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.15.1.5.2]
b. Abt 1752 d. 1 Mar 1831
11
George Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.15.1.5.3]
b. Abt 1752
11
Deborah Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.15.1.5.4]
b. Abt 1756 d. 1 Nov 1831
11
Lemuel Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.15.1.5.5]
b. Abt 1756 d. 8 Jul 1845
11
Sarah Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.15.1.5.6]
b. Abt 1758 d. 13 Nov 1845
11
Susannah Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.15.1.5.7]
b. Abt 1768 d. 19 Mar 1800
11
Mary Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.15.1.5.8]
b. Abt 1760
9
Johnathan Jenks
[1.2.6.1.1.2.1.15.2]
b. 17 Jul 1707 d. 1740
9
Dr. John Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.15.3]
b. 1710 d. 31 May 1776
8
Abigail Jenckes
[1.2.6.1.1.2.1.16]
b. 1676 d. 12 Mar 1756
Thomas Whipple
b. Abt 1671 d. 31 Mar 1766
9
Mary Harris Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.1]
b. Abt 1697
9
Thomas Whipple, Jr
[1.2.6.1.1.2.1.16.2]
b. Abt 1698 d. 20 Nov 1771
Mary Gary
b. 20 Jul 1699 d. 21 Feb 1767
10
Thomas Whipple, III
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.1]
b. 16 Jul 1723
Abigail Wood
11
Noah Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.1.1]
b. 23 Apr 1747
11
Ann Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.1.2]
b. 17 Jan 1749
11
Noah Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.1.3]
b. 3 May 1753
10
Mary Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.2]
b. 23 Jul 1725 d. Nov 1763
Moses Pelton
b. 1728 d. 16 Apr 1778
11
Hannah Pelton
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.2.1]
b. 3 Jan 1749 d. 10 May 1754
11
Moses Pelton, Jr
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.2.2]
b. 27 Jun 1751 d. 19 Jun 1809
11
Joel Pelton
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.2.3]
b. 5 Nov 1752 d. 7 Mar 1856
11
Mary Pelton
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.2.4]
b. 26 Feb 1754
11
Hannah Pelton
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.2.5]
b. 30 Aug 1755 d. 16 Feb 1817
11
Lemuel Pelton
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.2.6]
b. 1757
11
Elizabeth Pelton
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.2.7]
b. Nov 1763
10
Abigail Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.3]
b. 8 Jun 1727 d. 14 Jan 1728
10
Abraham Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.4]
b. 16 Feb 1728 d. 11 Mar 1729
10
Abigail Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.5]
b. 30 Jan 1729 d. 21 Apr 1806
Elijah Miner
b. Abt 1732 d. 18 Aug 1756
11
Abigail Miner
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.5.1]
b. 24 Dec 1756
11
Christiana Miner
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.5.2]
b. 29 Dec 1751 d. 24 Jun 1808
Thomas Davis
12
Elijah Davis
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.5.2.1]
b. 30 Jun 1775 d. 26 Feb 1834
12
Thomas Davis
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.5.2.2]
b. 13 Nov 1777
12
Sarah Davis
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.5.2.3]
b. 25 Apr 1780 d. 20 Aug 1848
12
Levina Davis
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.5.2.4]
b. 18 Apr 1782
12
Roswell Davis
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.5.2.5]
b. 18 Feb 1785 d. 14 May 1848
12
Polly Davis
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.5.2.6]
b. 31 Jul 1791 d. 28 Apr 1794
Jonathan Dickinson
b. 18 Nov 1738 d. 16 Oct 1762
11
Mary Dickinson
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.5.3]
b. 25 Dec 1758 d. 5 Mar 1759
11
Jonathan Dickinson
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.5.4]
b. 30 Sep 1760
11
Mary Dickinson
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.5.5]
b. Mar 1762 d. May 1850
Isaac Buck
b. 1739 d. 6 Feb 1825
11
Elijah Buck
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.5.6]
b. 11 Apr 1760 d. 24 Aug 1852
+
Submit Willson
b. 1765
11
Isaac Buck, Jr
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.5.7]
b. 11 Sep 1762
11
Susannah Buck
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.5.8]
b. 16 Dec 1764
11
William Buck
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.5.9]
b. 3 Nov 1766
11
Sarah Buck
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.5.10]
b. 22 Apr 1769 d. 1858
Samuel Parsons
b. 1767
12
Clarissa Parsons
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.5.10.1]
b. 21 Mar 1791 d. 23 Jan 1849 [
=>
]
12
Parmelia Parsons
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.5.10.2]
b. 12 Oct 1793
12
Harvey Parsons
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.5.10.3]
b. 3 Sep 1795 d. 28 Mar 1861
12
Samuel Parsons
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.5.10.4]
b. 19 Nov 1797
12
Elijah Parsons
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.5.10.5]
b. 1800
12
Lyman Parsons
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.5.10.6]
b. 10 Jun 1801 d. 5 Nov 1883
12
Sally Parsons
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.5.10.7]
b. 26 Jun 1803
12
Amity Parsons
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.5.10.8]
b. 1806 d. 23 Oct 1806
12
Orrin Parsons
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.5.10.9]
b. 3 Jul 1807
12
Elam Parsons
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.5.10.10]
b. 2 Aug 1809 d. 1893
12
Lucina Parsons
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.5.10.11]
b. 1811 d. 11 Nov 1879
12
Lura Amity Parsons
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.5.10.12]
b. 20 Aug 1813
11
Elenor Buck
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.5.11]
b. 15 Jun 1771
11
Lavina Buck
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.5.12]
b. 11 Dec 1773
10
Nathan Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.6]
b. 24 Dec 1731 d. 19 Mar 1813
Hannah White
b. 22 Aug 1729
11
Hannah Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.6.1]
b. 15 Apr 1758
11
Atener Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.6.2]
b. 4 Apr 1763
11
Thomas Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.6.3]
b. 23 Oct 1760
11
Nathan Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.6.4]
b. 30 Mar 1766 d. 1 Jul 1832
11
Susannah Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.6.5]
b. 18 Jan 1754
11
Patience Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.6.6]
b. 19 Jan 1756
10
Rachel Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.7]
b. 13 Oct 1733
Captain Nathaniel Hamlin
b. 7 Jan 1739 d. 27 Dec 1818
11
Charity Hamblin
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.7.1]
b. 30 Jan 1755
11
Levi Hamblin
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.7.2]
b. 11 Jun 1757
11
John Hamlin
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.7.3]
b. 12 Mar 1761 d. 30 Oct 1825
11
William Hamblin
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.7.4]
b. 17 May 1763
11
Asrariah Hamblin
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.7.5]
b. 27 Mar 1765
10
Ann Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.8]
b. 21 Oct 1735
Isaac Wyborn
b. 1727 d. Aft 1802
11
Prudence Wyborn
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.8.1]
b. 1762
11
William Gershon Wyborn
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.8.2]
b. 24 Jan 1777 d. 22 Mar 1857
11
Lucy Wyborn
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.8.3]
b. 1778
11
John M Wyborn
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.8.4]
b. Abt 1779
11
Bevil Granville Wyborn
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.8.5]
b. 15 Oct 1783 d. 9 May 1872
11
Daughter Wyborn
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.8.6]
b. Abt 1789
10
Elizabeth Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.9]
b. 26 Feb 1739
10
Amos Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.2.10]
b. 22 Jan 1742
9
Enoch Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.3]
b. Abt 1703 d. 18 Jan 1725
9
Abraham Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4]
b. Abt 1709 d. 3 Oct 1768
Mary Jones
b. 22 Apr 1709 d. 4 Nov 1780
10
Bathsheba Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.1]
b. 2 Feb 1731
10
Abraham Whipple, Jr
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.2]
b. 18 Mar 1734
10
Mary Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.3]
b. 1 Mar 1735 d. 6 Dec 1823
10
Samuel Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.4]
b. 7 Jan 1737 d. 28 Sep 1762
+
Oliver Evans
b. Abt 1741
10
Joseph Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.5]
b. 18 May 1740
Abigail Gary
b. 2 Jul 1743
11
Abraham Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.5.1]
b. 11 Feb 1768 d. 12 Jan 1852
10
Luther Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.6]
b. 7 Mar 1743 d. 1830
Eunice Gates
b. Abt 1744
11
Abram Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.6.1]
b. 11 Feb 1768 d. 12 Jan 1852
Asenath Sumner
b. 2 Aug 1768 d. 23 Dec 1851
12
Abigail Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.6.1.1]
b. 1794 d. 13 Apr 1870 [
=>
]
12
Louisa Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.6.1.2]
b. 1798 d. 12 Apr 1889
12
Eunice Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.6.1.3]
b. 1800
12
Daniel Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.6.1.4]
b. 20 Nov 1801 d. 26 Apr 1889 [
=>
]
12
Asenath "Sena" Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.6.1.5]
b. 1803 d. 27 May 1896 [
=>
]
12
Lydia Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.6.1.6]
b. 1806 d. 19 Sep 1880 [
=>
]
12
Henry Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.6.1.7]
b. 22 May 1807 d. 13 Jan 1895 [
=>
]
12
George "Leo" Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.6.1.8]
b. 18 May 1809 d. 19 Jul 1896 [
=>
]
12
Abraham Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.6.1.9]
b. 1810 d. Abt 1888 [
=>
]
12
Caroline Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.6.1.10]
b. 1811
12
Jane Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.6.1.11]
b. 1812 d. 3 Aug 1872
11
Eunice Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.6.2]
b. 18 Mar 1770 d. 26 Feb 1863
11
Polly Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.6.3]
b. 1772 d. 24 Aug 1847
Thomas Whittlesey
b. 28 Feb 1772 d. 2 Mar 1847
12
Lucy Whittlesey
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.6.3.1]
b. Jun 1797 d. Jul 1865
12
Maria Whittlesey
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.6.3.2]
b. 9 Apr 1805
12
Eliza Whittlesey
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.6.3.3]
b. 19 Aug 1807 d. Abt 1831 [
=>
]
12
Thomas Jefferson Whittlesey
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.6.3.4]
b. 13 Jun 1812
12
Isaac Whittlesey
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.6.3.5]
b. 25 Mar 1815 [
=>
]
12
Francis Elmira Whittlesey
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.6.3.6]
b. 30 Sep 1817
11
Elizabeth Gates Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.6.4]
b. 19 Aug 1775 d. 26 Jun 1862
John Sawyer
b. 10 May 1773 d. 21 Apr 1871
12
Abraham Sawyer
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.6.4.1]
b. 1 Feb 1796 d. 9 Apr 1868
12
John Sawyer
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.6.4.2]
b. 14 Apr 1805 d. 26 Feb 1880 [
=>
]
12
Issac Sawyer
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.6.4.3]
b. 3 Sep 1816 d. 1 Jul 1912
12
Ira Sawyer
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.6.4.4]
b. 3 Sep 1816 d. 28 Nov 1899 [
=>
]
11
Lydia Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.6.5]
b. 1777
11
Martha Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.6.6]
b. 1781
11
Clarissa Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.6.7]
b. 11 Mar 1784
Joel Sawyer, Jr
b. 7 Aug 1781 d. 1 Sep 1859
12
Joel W Sawyer
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.6.7.1]
b. 6 Dec 1815 d. 25 Dec 1908
11
Henry Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.6.8]
b. Abt 1785 d. Aft 1800
11
Thomas Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.6.9]
b. 1787 d. 18 Sep 1887
Cynthia Allen
b. 3 Feb 1788 d. 30 Oct 1861
12
Allen G Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.6.9.1]
b. 1812 d. Aft 8 Jun 1880 [
=>
]
12
Thomas Corbin Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.6.9.2]
b. 28 Mar 1814 d. 9 Feb 1892 [
=>
]
12
Ruth Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.6.9.3]
b. Abt 1816
12
Abigail Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.6.9.4]
b. Abt 1818
12
Ira Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.6.9.5]
b. 2 Jan 1820 d. 7 Oct 1895
10
Anna Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7]
b. 17 Feb 1744 d. 1811
Robert Follett
b. 27 Apr 1739 d. 9 Apr 1810
11
Robert Follett
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7.1]
b. 15 Sep 1764
Molly Knap
b. 17 Apr 1766
12
Nancy Follett
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7.1.1]
b. Aft 1800
11
Anna Follett
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7.2]
b. 22 Mar 1766 d. 23 Apr 1839
Joseph Ford
b. 29 Feb 1768 d. 30 Jan 1846
12
Sarah Ford
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7.2.1]
b. 1793 d. 1842 [
=>
]
12
John Perley Ford
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7.2.2]
b. 6 Dec 1794 d. 18 Sep 1869 [
=>
]
12
Anna Ford
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7.2.3]
b. 1796
12
Mary Ophria Ford
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7.2.4]
b. 1798
12
Joseph Ford
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7.2.5]
b. 12 May 1800 d. 26 Sep 1882 [
=>
]
12
Chloe Ford
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7.2.6]
b. 1803 [
=>
]
11
Mary Follett
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7.3]
b. 10 Oct 1767 d. Bef 1810
11
Abigail Follett
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7.4]
b. 18 Feb 1770
John Delong
b. Abt 1768
12
Eunice Delong
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7.4.1]
b. 2 Dec 1796 d. 20 Feb 1884
11
Calvin Follett
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7.5]
b. 6 Jan 1772 d. 21 Dec 1856
Drusilla Kempton
b. Abt 1787 d. 8 Apr 1856
12
William Follett
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7.5.1]
b. 18 Dec 1801
12
Benjamin Follett
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7.5.2]
b. 22 Oct 1803 d. 11 Dec 1892 [
=>
]
12
Ephraim Follett
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7.5.3]
b. 24 Dec 1805 d. 1 May 1864 [
=>
]
12
Calvin Follett
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7.5.4]
b. 1807 [
=>
]
12
Anna Follett
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7.5.5]
b. 1809 d. 24 Aug 1832
12
Daughter Follett
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7.5.6]
b. 1810
12
Daughter Follett
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7.5.7]
b. 1813
12
Hiram Follett
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7.5.8]
b. 1 Nov 1816 d. 20 Jan 1892 [
=>
]
12
Louisa Follett
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7.5.9]
b. 1819
12
Calvin Follett
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7.5.10]
b. 1822
12
Mary Jane Follett
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7.5.11]
b. 1825 [
=>
]
12
Fanny Follett
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7.5.12]
b. 1831 d. 11 Mar 1832
11
Elijah Follett
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7.6]
b. 29 Mar 1775 d. Jul 1816
Sabra Hill
b. 28 Apr 1779 d. 24 Apr 1842
12
John Follett
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7.6.1]
b. Abt 1799
12
Sarah "Sally" Follett
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7.6.2]
b. Abt 1803 [
=>
]
12
Samuel Follett
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7.6.3]
b. 26 Dec 1803 d. 1885 [
=>
]
12
Orpha Follett
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7.6.4]
b. Abt 1805
12
Daniel Edward Follett
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7.6.5]
b. 11 Nov 1807 d. 27 Nov 1901 [
=>
]
12
Eunice Follett
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7.6.6]
b. Abt 1809
12
Ann Follett
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7.6.7]
b. Abt 1811
12
Elsie Follett
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7.6.8]
b. 1811
12
Joseph Follett
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7.6.9]
b. 17 Jun 1814 d. 1897 [
=>
]
11
Samuel Follett
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7.7]
b. 2 Apr 1776
Rebecca
b. Abt 1778
12
Permelia Follett
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7.7.1]
b. Abt 1817
11
William Follett
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7.8]
b. 3 Mar 1778 d. 1853
Sybil Blackman
b. 1780 d. Bef 1850
12
Betsy Follett
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7.8.1]
b. 1808
12
Ann Follett
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7.8.2]
b. 1810
12
John Follett
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7.8.3]
b. 1813 [
=>
]
12
William Follett
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7.8.4]
b. 1820 [
=>
]
12
Hannah Follett
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7.8.5]
b. 21 Feb 1824 d. 21 Oct 1898
12
Samuel B Follett
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7.8.6]
b. 6 Nov 1827 d. 13 Feb 1920 [
=>
]
12
Henry Follett
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7.8.7]
b. 15 Oct 1829 d. 31 May 1905
11
Eunice Follett
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7.9]
b. 28 Mar 1779
Joseph Baker
b. Abt 1777
12
Joseph Baker, Jr
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7.9.1]
b. Abt 1799
12
John Baker
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7.9.2]
b. Abt 1801
12
Erastus Baker
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7.9.3]
b. Abt 1803
12
Norma Baker
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7.9.4]
b. Abt 1805
12
Maria Baker
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7.9.5]
b. 1809 [
=>
]
11
John Follett
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.7.10]
b. 22 Aug 1783
+
Lydia Reed
b. 1785
10
Calvin Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.8]
b. 17 Aug 1745 d. 10 Nov 1762
10
Deborah Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.9]
b. 6 Aug 1747
10
Daniel Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.10]
b. 7 Sep 1749 d. 1798
Deborah Hildreth
b. 5 May 1755 d. Abt 1789
11
Samuel Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.10.1]
b. 1777 d. Aft 1800
11
Daniel Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.10.2]
b. 27 Aug 1779 d. 27 Sep 1839
Mary Tiffany
b. 17 Jun 1777 d. 12 Sep 1845
12
Cynthia Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.10.2.1]
b. 15 Jan 1805 d. 1889 [
=>
]
12
Samuel Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.10.2.2]
b. 21 Dec 1808 d. 9 Jan 1887 [
=>
]
12
Almira Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.10.2.3]
b. 13 Jun 1810 d. 4 Feb 1889 [
=>
]
12
Phoebe Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.10.2.4]
b. 13 Aug 1813 d. 18 Nov 1846 [
=>
]
12
Carum Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.10.2.5]
b. 12 Aug 1815 d. 1843
12
Gerua Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.10.2.6]
b. 12 Aug 1815 d. 18 Sep 1848
12
Nelson Wheeler Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.10.2.7]
b. 11 Jul 1818 d. 5 Jul 1887 [
=>
]
11
Richard Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.10.3]
b. Abt 1781 d. 25 May 1862
11
Roswell Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.10.4]
b. 1783 d. 25 May 1862
Melinda Gates
b. 26 May 1802 d. Abt 1827
12
Abram Gates Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.10.4.1]
b. 19 Oct 1826 d. 1913 [
=>
]
Hannah Weeks
b. 14 Oct 1806 d. 7 Apr 1889
12
William Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.10.4.2]
b. Mar 1834 d. Aft Jun 1900
12
Sarah Ann Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.10.4.3]
b. Abt 16 Feb 1834 d. 18 Jan 1919
12
Clarissa Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.10.4.4]
b. Feb 1838 d. 30 Jul 1921
12
Ella Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.10.4.5]
b. Abt 1839
12
Jane Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.10.4.6]
b. 1843
12
Emoline Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.10.4.7]
b. Abt 1848 d. 31 Mar 1923
12
Caroline Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.10.4.8]
b. Abt 1848
12
Frank E Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.10.4.9]
b. May 1857 d. Aft 1904
11
Polly Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.10.5]
b. Abt 1785
11
Lucy Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.10.6]
b. Abt 1787
+
Bingham
b. 1783
11
Cynthia Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.10.7]
b. 1789 d. 15 Feb 1856
Ebenezer Root
b. 17 Dec 1760 d. 12 Feb 1842
12
Jerusha Root
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.10.7.1]
b. 22 Feb 1804 d. 8 Jul 1889 [
=>
]
12
Charlotte Root
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.10.7.2]
b. 5 Jul 1805 d. 26 Oct 1900 [
=>
]
12
Polly Root
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.10.7.3]
b. 16 Apr 1807 d. 9 Dec 1853
12
Daniel W Root
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.10.7.4]
b. 29 May 1809 d. 23 Oct 1846
12
Harriet Root
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.10.7.5]
b. 27 Aug 1811 d. 26 Oct 1901
12
Alanson Root
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.10.7.6]
b. 19 Nov 1814 d. 1817
12
Cyras Root
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.10.7.7]
b. 10 Feb 1817
12
Silas Root
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.10.7.8]
b. 10 Feb 1817 d. 1 Apr 1904
10
Thomas Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.11]
b. 16 Mar 1751 d. 1833
Lydia Gates
b. Abt 1761 d. 17 Mar 1795
11
Lydia Gates Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.11.1]
b. 24 Jul 1779 d. 1 Sep 1864
Jonathan Carver Ames
b. 18 Mar 1774 d. 26 Apr 1853
12
Alvin Ames
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.11.1.1]
b. 8 Mar 1800 d. 11 Jun 1870 [
=>
]
12
Chester Ames
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.11.1.2]
b. 9 May 1801 d. 28 Aug 1891 [
=>
]
12
Joseph Ames
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.11.1.3]
b. 28 Sep 1802 d. 11 Apr 1851 [
=>
]
12
Mary Ames
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.11.1.4]
b. 3 Feb 1804 d. 23 Nov 1884
12
Johnathan Carver Ames
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.11.1.5]
b. 18 Apr 1807 d. 26 Mar 1868 [
=>
]
12
Thomas Whipple Ames
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.11.1.6]
b. 7 Apr 1808 d. 18 Jan 1885
12
Walter Whipple Ames
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.11.1.7]
b. 21 Jun 1810 d. 26 Apr 1887 [
=>
]
12
Caroline Ames
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.11.1.8]
b. 1 Apr 1811 d. 17 Apr 1828
12
Valeria Ames
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.11.1.9]
b. 24 Jun 1813 d. 15 Sep 1856
12
Levi Ames
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.11.1.10]
b. 11 Jun 1816 d. 31 Jul 1909
12
Phoebe Tabor Ames
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.11.1.11]
b. 18 Jun 1818 [
=>
]
12
Lydia Whipple Ames
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.11.1.12]
b. 15 Nov 1820 d. 25 Feb 1903 [
=>
]
11
Thomas Jefferson Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.11.2]
b. 1787 d. 23 Jan 1835
Phebe Taber
b. Aug 1784 d. 17 Aug 1823
12
Alonzo A Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.11.2.1]
b. 27 Feb 1811 d. 11 Mar 1887 [
=>
]
12
Thomas Jefferson Whipple, Jr
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.11.2.2]
b. 30 Jan 1816 d. 21 Dec 1889 [
=>
]
12
Caroline B Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.11.2.3]
b. 1 Apr 1820 d. 5 Oct 1910 [
=>
]
11
Mattie Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.11.3]
b. 8 May 1789 d. 4 Sep 1877
Paul Tabor
b. 12 Aug 1788 d. 3 Sep 1878
12
Mialma Tabor
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.11.3.1]
b. 8 Jan 1814 d. 26 Aug 1894 [
=>
]
12
Ann Tabor
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.11.3.2]
b. 5 Jul 1828 d. 29 Nov 1904 [
=>
]
11
Son Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.11.4]
b. Bef 1790 d. Aft 1790
11
Walter Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.11.5]
b. 28 Feb 1792 d. 24 Dec 1882
Susan A Donaldson
b. Abt 1795
12
Lothario Danielson Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.11.5.1]
b. 14 Sep 1831 d. 18 Nov 1847
Ruth Baker
b. Abt 1806 d. Aft 1880
12
Susan Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.11.5.2]
b. 1846
12
James Henry Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.4.11.5.3]
b. Dec 1857 [
=>
]
9
Patience Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.5]
b. Abt 1709
+
John Olney
b. Abt 1707
9
Noah Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.6]
b. Abt 1711
9
Nathan Whipple
[1.2.6.1.1.2.1.16.7]
b. Abt 1713
7
Elizabeth Jenckes
[1.2.6.1.1.2.2]
b. Abt 1630 d. 2 Nov 1638
Elizabeth
b. Abt 1626 d. Jul 1679
7
Samuel Jenckes
[1.2.6.1.1.2.3]
b. Abt 1654 d. 13 Mar 1738
7
Deborah Jenckes
[1.2.6.1.1.2.4]
b. 11 Jun 1658 d. 1683
7
John Jenckes
[1.2.6.1.1.2.5]
b. 27 Jul 1660 d. 8 Mar 1698
7
Daniel Jenckes
[1.2.6.1.1.2.6]
b. 19 Apr 1663 d. 1736
Katherine Balcolm
b. Abt 1664 d. 1729
8
Mary Jenckes
[1.2.6.1.1.2.6.1]
b. Abt 1692 d. 22 Apr 1784
Joseph Weatherhead
b. Abt 1688
9
Jeremiah Weatherhead
[1.2.6.1.1.2.6.1.1]
b. 22 Jan 1714 d. 14 May 1799
9
Daniel Weatherhead
[1.2.6.1.1.2.6.1.2]
b. 25 Aug 1717 d. 16 Jan 1794
Berthia
10
John Weatherhead
[1.2.6.1.1.2.6.1.2.1]
b. 27 Dec 1740 d. 28 Jan 1817
Tabatha Kempton
b. Abt 1748 d. 9 Apr 1830
11
Freelove Weatherhead
[1.2.6.1.1.2.6.1.2.1.1]
b. 14 Dec 1771 d. 9 Jul 1832
11
Welcome Weatherhead
[1.2.6.1.1.2.6.1.2.1.2]
b. 8 Feb 1776
11
Lavinia Weatherhead
[1.2.6.1.1.2.6.1.2.1.3]
b. 1 Sep 1778
11
Susanna Weatherhead
[1.2.6.1.1.2.6.1.2.1.4]
b. 3 Jan 1781
11
Mary Weatherhead
[1.2.6.1.1.2.6.1.2.1.5]
b. 11 Feb 1784
11
Ruth Tabitha Weatherhead
[1.2.6.1.1.2.6.1.2.1.6]
b. 9 Mar 1786 d. 6 Dec 1864
David O Whipple
b. 22 Jan 1782 d. 25 Apr 1847
12
Washington Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.1.2.1.6.1]
b. 24 Feb 1813 d. 11 Mar 1895 [
=>
]
12
Amey Ann Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.1.2.1.6.2]
b. 2 Sep 1814 d. 18 Jun 1898
12
Sylvester Kempton Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.1.2.1.6.3]
b. 20 Mar 1816 d. 29 Aug 1880
12
John Weatherhead Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.1.2.1.6.4]
b. 20 Jun 1818 d. 6 May 1879
12
Mary Amanda Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.1.2.1.6.5]
b. 18 Dec 1821 d. 1872
12
David Olney Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.1.2.1.6.6]
b. 15 Jan 1824 d. 2 Aug 1869
12
Ruth Jane Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.1.2.1.6.7]
b. 16 Mar 1827 d. 16 Oct 1891
12
Erastus Ross Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.1.2.1.6.8]
b. 4 Jun 1830 d. 1912
11
Whipple Weatherhead
[1.2.6.1.1.2.6.1.2.1.7]
b. 22 Jun 1788 d. 28 Feb 1867
11
John Weatherhead
[1.2.6.1.1.2.6.1.2.1.8]
b. 22 Feb 1790 d. 30 Oct 1870
9
Joseph Weatherhead
[1.2.6.1.1.2.6.1.3]
b. 22 Apr 1720
9
John Weaatheerhead
[1.2.6.1.1.2.6.1.4]
b. 21 Sep 1728
8
Elizabeth Jenckes
[1.2.6.1.1.2.6.2]
b. 24 Aug 1694 d. 25 Apr 1768
8
Abigail Jenckes
[1.2.6.1.1.2.6.3]
b. 28 Jul 1696 d. Bef 15 Mar 1737
8
Martha Jenckes
[1.2.6.1.1.2.6.4]
b. 5 Aug 1698 d. 22 Jun 1751
John Arnold
b. 29 May 1697 d. 12 Mar 1727
9
David Arnold
[1.2.6.1.1.2.6.4.1]
b. Abt 1710 d. 1 Feb 1786
Mercy Whipple
b. 15 Mar 1721
10
Elisha Arnold
[1.2.6.1.1.2.6.4.1.1]
b. 1754 d. 27 May 1838
10
Stephen Arnold
[1.2.6.1.1.2.6.4.1.2]
b. Aft 1756
10
David Arnold
[1.2.6.1.1.2.6.4.1.3]
10
Eleazer Aldrich
[1.2.6.1.1.2.6.4.1.4]
10
Abigail Arnold
[1.2.6.1.1.2.6.4.1.5]
10
Martha Arnold
[1.2.6.1.1.2.6.4.1.6]
9
Moses Arnold
[1.2.6.1.1.2.6.4.2]
b. 1718
9
Captain Noah Arnold
[1.2.6.1.1.2.6.4.3]
b. 1720 d. 1800
9
Daniel Arnold
[1.2.6.1.1.2.6.4.4]
b. 1724
9
Aaron Arnold
[1.2.6.1.1.2.6.4.5]
b. 1726
8
Susanna Jenckes
[1.2.6.1.1.2.6.5]
b. 24 May 1700 d. 18 Mar 1732
8
Daniel Jenckes
[1.2.6.1.1.2.6.6]
b. 12 Mar 1702 d. 24 Jan 1789
Mercy Sprague
b. 17 Jun 1703 d. 19 Apr 1749
9
Catherine Jenckes
[1.2.6.1.1.2.6.6.1]
b. 23 Mar 1729
9
Jeremiah Jenckes
[1.2.6.1.1.2.6.6.2]
b. 12 Feb 1730 d. 17 Feb 1819
9
Hannah Jenckes
[1.2.6.1.1.2.6.6.3]
b. 1 Nov 1732 d. 25 Nov 1794
9
John Jenckes
[1.2.6.1.1.2.6.6.4]
b. 2 Nov 1734 d. 22 Feb 1818
9
Phebe Jencks
[1.2.6.1.1.2.6.6.5]
b. 14 Feb 1735 d. 1828
9
Mercy Jenckes
[1.2.6.1.1.2.6.6.6]
b. 2 Sep 1737 d. 18 Feb 1797
9
Mary Jenckes
[1.2.6.1.1.2.6.6.7]
b. 2 Sep 1737
9
David Jenckes
[1.2.6.1.1.2.6.6.8]
b. 21 Jun 1739 d. 3 Dec 1822
9
Daniel Jenckes
[1.2.6.1.1.2.6.6.9]
b. 19 Mar 1743 d. 1801
Sarah Whipple
b. 26 Dec 1741 d. Aft May 1784
10
Gideon Jenckes
[1.2.6.1.1.2.6.6.9.1]
b. 31 May 1764 d. 25 Sep 1822
Anna White
b. 9 Apr 1769 d. 15 Oct 1850
11
Daniel Jenckes
[1.2.6.1.1.2.6.6.9.1.1]
b. 24 Aug 1788 d. 1846
Sophia Cargill
b. 1793 d. 3 Feb 1862
12
Susan Jenckes
[1.2.6.1.1.2.6.6.9.1.1.1]
b. 1812 d. 17 Oct 1837
12
Carolina A Jenckes
[1.2.6.1.1.2.6.6.9.1.1.2]
b. 1815 d. 4 Jun 1837
12
Leprellet Jenckes
[1.2.6.1.1.2.6.6.9.1.1.3]
b. 1816 d. 16 Jan 1894
12
Sarah W Jenckes
[1.2.6.1.1.2.6.6.9.1.1.4]
b. 1819 d. 24 Dec 1876
12
Daniel A Jenckes
[1.2.6.1.1.2.6.6.9.1.1.5]
b. 1824 d. 10 Jul 1886
12
Louisa Jenckes
[1.2.6.1.1.2.6.6.9.1.1.6]
b. Abt 1826 d. 1 Sep 1880
12
Sophronia Jenckes
[1.2.6.1.1.2.6.6.9.1.1.7]
b. Abt 1828
12
Mary C Jenckes
[1.2.6.1.1.2.6.6.9.1.1.8]
b. 1831 d. 5 Sep 1836
12
Charlotte Anne Jenckes
[1.2.6.1.1.2.6.6.9.1.1.9]
b. Sep 1835 d. 2 Apr 1921 [
=>
]
11
Isaac Jenckes
[1.2.6.1.1.2.6.6.9.1.2]
b. 13 Dec 1790 d. 3 Apr 1851
11
William Jenckes
[1.2.6.1.1.2.6.6.9.1.3]
b. 2 Jan 1796
11
Whipple Jenckes
[1.2.6.1.1.2.6.6.9.1.4]
b. 2 Nov 1798
11
Susanna Jenckes
[1.2.6.1.1.2.6.6.9.1.5]
b. 2 Jun 1803
11
Rhoda Jenckes
[1.2.6.1.1.2.6.6.9.1.6]
b. 21 Mar 1808
Rhoda Cruff
b. 9 Feb 1749
10
Lemuel Jenckes
[1.2.6.1.1.2.6.6.9.2]
b. 8 Aug 1768
10
Sarah Jenckes
[1.2.6.1.1.2.6.6.9.3]
b. 8 Sep 1769
10
Jabez Jenckes
[1.2.6.1.1.2.6.6.9.4]
b. 27 May 1784 d. 1805
10
Captain Sterry Jenckes
[1.2.6.1.1.2.6.6.9.5]
b. 6 Feb 1787 d. 26 Nov 1853
Anne Nancy Dexter
b. 1782
11
Horatio Nelson Jenckes
[1.2.6.1.1.2.6.6.9.5.1]
b. 8 Aug 1810 d. 30 Dec 1828
11
Elcy Ann Jenckes
[1.2.6.1.1.2.6.6.9.5.2]
b. 3 Sep 1813 d. 12 Dec 1828
11
Jabez Walcott Jenckes
[1.2.6.1.1.2.6.6.9.5.3]
b. 7 Jan 1815 d. 11 Jan 1883
11
Rhoda Ann Jenckes
[1.2.6.1.1.2.6.6.9.5.4]
b. 15 Jan 1818 d. 7 Aug 1847
Levi Carpenter
b. 28 Oct 1803 d. 22 May 1876
12
George Nelson Carpenter
[1.2.6.1.1.2.6.6.9.5.4.1]
b. 12 Oct 1836 d. 8 Apr 1839
12
Adeline Dexter Carpenter
[1.2.6.1.1.2.6.6.9.5.4.2]
b. 11 Mar 1838 [
=>
]
12
Rebecca Sheldon Carpenter
[1.2.6.1.1.2.6.6.9.5.4.3]
b. 6 Jun 1840 d. 17 Jul 1921 [
=>
]
12
Elsie Jenks Carpenter
[1.2.6.1.1.2.6.6.9.5.4.4]
b. 5 Mar 1842
12
Charley Carpenter
[1.2.6.1.1.2.6.6.9.5.4.5]
b. 27 Jan 1847 d. 28 Nov 1872
11
Diana Jenckes
[1.2.6.1.1.2.6.6.9.5.5]
b. 7 Apr 1820 d. 4 Mar 1890
11
Albert Cheney Jenckes
[1.2.6.1.1.2.6.6.9.5.6]
b. 16 Mar 1822 d. 22 Dec 1887
11
Mary Humphry Jenckes
[1.2.6.1.1.2.6.6.9.5.7]
b. 24 Jan 1824 d. 17 Mar 1914
11
Charles Erastus Jenckes
[1.2.6.1.1.2.6.6.9.5.8]
b. 10 Oct 1825 d. 7 Apr 1896
11
Ardelia Jenckes
[1.2.6.1.1.2.6.6.9.5.9]
b. 9 Sep 1827 d. 8 Sep 1925
11
Henry Hartwell Jenckes
[1.2.6.1.1.2.6.6.9.5.10]
b. 14 Aug 1829
11
Nathaniel Miles Jenckes
[1.2.6.1.1.2.6.6.9.5.11]
b. 28 Aug 1831 d. 5 Jul 1892
11
George F Jenckes
[1.2.6.1.1.2.6.6.9.5.12]
b. 7 May 1834 d. 27 May 1922
9
Mary Jenckes
[1.2.6.1.1.2.6.6.10]
b. 3 Jun 1746 d. 15 Mar 1800
8
Hannah Jenckes
[1.2.6.1.1.2.6.7]
b. 15 Feb 1704 d. 22 Nov 1723
8
Ruth Jenckes
[1.2.6.1.1.2.6.8]
b. 9 Dec 1705
Job Whipple, Jr
b. 1704 d. 25 Feb 1729
9
Ephraim Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.8.1]
b. Abt 1727 d. 1805
Sylvia Lapham
b. 8 May 1731 d. 11 May 1805
10
Job Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.1]
b. 30 Mar 1749 d. 18 Sep 1822
Elizabeth Freelove Carpenter
b. 27 Apr 1749 d. 16 Feb 1834
11
Sylvia Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.1.1]
b. 9 Sep 1773 d. 20 Oct 1834
Samuel Heath
b. 19 Apr 1773 d. 1851
12
William Anson Heath
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.1.1.1]
b. 17 May 1795 d. 28 Jul 1855 [
=>
]
12
Maria Heath
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.1.1.2]
b. 14 Jun 1807 [
=>
]
11
Olive Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.1.2]
b. 9 Feb 1775 d. 11 Jan 1839
James Tafft
12
Elizabeth Tafft
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.1.2.1]
b. 15 Sep 1792 d. 24 Jul 1865 [
=>
]
Daniel M Beers
12
Sidney Alexander Beers
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.1.2.2]
b. 8 Feb 1809
11
David Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.1.3]
b. 30 Jul 1776 d. 9 Jul 1833
Elizabeth Betsey Tefft
b. 27 Sep 1788 d. 11 Feb 1866
12
Polly Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.1.3.1]
b. 23 Dec 1798 d. 5 May 1848 [
=>
]
12
Malinda Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.1.3.2]
b. Abt 24 Dec 1806 d. 12 Jun 1807
12
Ira D Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.1.3.3]
b. 2 Apr 1808 [
=>
]
12
Ann Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.1.3.4]
b. Abt 1812
12
Job T Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.1.3.5]
b. Abt 1817
12
Henry Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.1.3.6]
b. Abt 1826 [
=>
]
12
Adah D Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.1.3.7]
b. Abt 1832
12
Helen Jane Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.1.3.8]
b. Abt 1829 [
=>
]
11
Otis Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.1.4]
b. 18 Nov 1777 d. 20 Oct 1863
11
Daniel Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.1.5]
b. 8 Oct 1782 d. 8 Nov 1841
Elizabeth McNitt
b. Abt 1790 d. Bef 1840
12
Malinda Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.1.5.1]
b. 15 Jan 1812 d. 30 May 1816
12
Olive Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.1.5.2]
b. 1813 d. 1866 [
=>
]
12
Malinda Ann Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.1.5.3]
b. 20 May 1816 d. 25 Apr 1817
12
Hiram Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.1.5.4]
b. 29 Jun 1818 d. 22 Mar 1858 [
=>
]
11
Lydia Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.1.6]
b. 10 Oct 1784 d. 25 Nov 1870
William Mowry
b. 27 Jul 1779 d. 23 Mar 1845
12
William Henry Mowry
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.1.6.1]
b. 23 Jul 1811 d. 22 Oct 1850 [
=>
]
12
Leroy Mowry
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.1.6.2]
b. 26 Aug 1808 [
=>
]
12
Ann Caroline Mowry
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.1.6.3]
b. 13 Oct 1809 d. 3 Feb 1875 [
=>
]
12
Mary Potter Mowry
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.1.6.4]
b. Abt 1811
12
Mary Elizabeth Mowry
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.1.6.5]
b. 21 Nov 1820 [
=>
]
11
Betsey Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.1.7]
b. 16 Aug 1789 d. 16 Aug 1791
11
Anna Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.1.8]
b. 28 Mar 1791 d. 15 May 1839
11
Elizabeth Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.1.9]
b. 6 Oct 1799
10
David Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.2]
b. Abt 1748 d. Aft 1775
10
Ephriam Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.3]
b. Abt 1753
Zerviah Mason
b. 1 Nov 1753 d. 11 Nov 1784
11
Mason Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.3.1]
b. Abt 1780 d. 1842
10
Daughter Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.4]
b. Abt 1753
Pricilla Appleby
b. Abt 1730
10
Phoebe Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.5]
b. 4 Nov 1755
10
Mary Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.6]
b. 15 Dec 1757
10
Hannah Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.7]
b. 1759
Amaziah Jillson
b. 28 Oct 1750
11
James Jillson
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.7.1]
b. 1781
12
Milton Jillson
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.7.1.1]
b. 1805
11
Charles Jillson
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.7.2]
b. 1785
11
Cynthia Jillson
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.7.3]
b. 1788
+
Richard Tingley
b. 1785
11
Phila Jillson
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.7.4]
b. 1791
Joseph Philbrook
b. 19 Sep 1788
12
Ann Eliza Phillbrook
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.7.4.1]
b. 26 Jul 1824
12
Charles C W Phillbrook
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.7.4.2]
b. 4 Jul 1828 d. 18 Mar 1864 [
=>
]
12
Cynthia Jane Phillbrook
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.7.4.3]
b. 11 Oct 1830
11
David Jillson
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.7.5]
b. 28 Nov 1793 d. 9 Jun 1841
Eleanor Dutcher
b. 3 May 1776 d. 1813
12
Sidney Jillson
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.7.5.1]
b. 16 Jul 1813 d. 1876 [
=>
]
Desire Bennett
b. 1795 d. 1827
12
William Whipple Jillson
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.7.5.2]
b. 16 Jan 1819 d. 24 Mar 1891 [
=>
]
12
Harrison Harmon Jillson
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.7.5.3]
b. 17 Dec 1821 d. 8 Oct 1862 [
=>
]
12
Harriet Jillson
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.7.5.4]
b. 2 Jun 1823 d. 1845
12
Cynthia A Jillson
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.7.5.5]
b. 24 Apr 1825 [
=>
]
Emerancy Bixby
b. 24 Jun 1806
12
Susan Jillson
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.7.5.6]
b. 2 Feb 1830 [
=>
]
12
Eleanor Jillson
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.7.5.7]
b. 5 Oct 1831
12
David Jillson
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.7.5.8]
b. 1 Aug 1833 [
=>
]
12
Desire Jillson
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.7.5.9]
b. 24 Jun 1836 d. 1848
12
Emma Jillson
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.7.5.10]
b. 3 May 1838 d. 1845
12
Josephine Jillson
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.7.5.11]
b. 2 Jun 1841 [
=>
]
11
William D Jillson
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.7.6]
b. 1797 d. 1854
Emily Bryant
b. 1794 d. 1867
12
Mary A Jillson
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.7.6.1]
b. 1827 [
=>
]
12
James B Jillson
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.7.6.2]
b. 1828 [
=>
]
12
William Wallace Jillson
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.7.6.3]
b. 1830 [
=>
]
12
Francis E Jillson
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.7.6.4]
b. 1832
12
Dwight E Jillson
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.7.6.5]
b. 1834 [
=>
]
12
George C Jillson
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.7.6.6]
d. 31 May 1869
11
Otis Jillson
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.7.7]
b. 1800 d. 7 Jan 1853
Mary Francis
b. 14 Aug 1816 d. 16 Aug 1837
12
James Harvey Jillson
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.7.7.1]
b. 1833 d. 4 Nov 1868 [
=>
]
12
Lyman Jillson
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.7.7.2]
b. 25 Dec 1836
+
Mary Parmenter
b. 1800 d. 1870
11
Harvey Jillson
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.7.8]
b. 1802
10
Marmaduke Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.8]
b. 30 Jan 1761 d. 26 Dec 1836
Wealthy Whipple
b. 3 Mar 1764 d. 9 Nov 1867
11
Aretas Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.8.1]
b. 2 Jun 1784
10
Anne Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.9]
b. Abt 1765
+
John Carpenter
b. Abt 1760
10
Barneville "Barney" Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.10]
b. 3 Aug 1769 d. 19 Dec 1846
Anna Ramsdell
b. 1770 d. 1830
11
Barneville Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.10.1]
b. 17 Jul 1791 d. 1 Feb 1868
Betsey Lott
b. 20 Oct 1797 d. 17 Feb 1885
12
Lyman L Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.10.1.1]
b. 1821 d. 16 Feb 1872
12
Sarah Ann Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.10.1.2]
b. 1824 d. 7 Nov 1902
12
Phebe Jane Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.10.1.3]
b. 16 Apr 1827 d. 1917 [
=>
]
12
Evelene Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.10.1.4]
b. 2 Aug 1830 d. 15 Feb 1905 [
=>
]
12
Irene Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.10.1.5]
b. 2 Aug 1830
12
Otis B Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.10.1.6]
b. 1836 d. 9 Dec 1863
11
Ruth Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.10.2]
b. 18 Feb 1794 d. 2 Jun 1855
11
Sarah Ann Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.10.3]
b. 1796 d. 28 May 1863
Thomas Mosher
b. 28 Feb 1782 d. 18 Jun 1852
12
Anna Mosher
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.10.3.1]
b. 26 Apr 1816 d. 1823
12
Gideon Henry Mosher
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.10.3.2]
b. 20 Nov 1818 d. 31 Jan 1905
12
Mary Jane Mosher
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.10.3.3]
b. 27 Jan 1821 d. 21 Aug 1903
12
Emeline Mosher
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.10.3.4]
b. 22 Mar 1824 d. 12 Aug 1904
12
Ruth Mosher
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.10.3.5]
b. 3 Jun 1826
12
Ephraim Pettis Mosher
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.10.3.6]
b. 22 Sep 1828 d. 18 Dec 1914
12
George D Mosher
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.10.3.7]
b. 6 Sep 1833 d. 28 Sep 1893
12
William Whipple Mosher
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.10.3.8]
b. 17 Jun 1836
12
Isabella Mosher
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.10.3.9]
b. 1837 d. 8 Jun 1882
12
Cornelia Marion Mosher
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.10.3.10]
b. 3 Dec 1840 d. 29 Mar 1909
11
Annie Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.10.4]
b. 1801
11
Welcome Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.10.5]
b. 1803 d. 9 May 1855
10
Jenckes B Whipple
[1.2.6.1.1.2.6.8.1.11]
b. 3 Aug 1769 d. 19 Dec 1846
8
Joseph Jenckes
[1.2.6.1.1.2.6.9]
b. 5 Mar 1708
6
Lydia Jenckes
[1.2.6.1.1.3]
b. Abt 1600
6
Joseph B Jenckes
[1.2.6.1.1.4]
b. 1607 d. 1642
6
John Jenckes
[1.2.6.1.1.5]
b. 1610
+
Hanna Glinn
5
Jonas Jenckes
[1.2.6.1.2]
b. 1562 d. 24 Apr 1622
Hannah Pitts
b. Abt 1562
6
Jonas Jenckes
[1.2.6.1.2.1]
b. Abt 1614 d. 1 Aug 1633
6
Richard Jenckes
[1.2.6.1.2.2]
c. 13 Jul 1617 bur. 17 Apr 1619
6
Joshua Jenckes
[1.2.6.1.2.3]
c. 5 Mar 1619
3
Anne Spencer
[1.2.7]
b. Abt 1510
3
Jane Spencer
[1.2.8]
b. 1519 d. Abt 1560
2
Jane Spencer
[1.3]
b. 1465 d. 22 Feb 1525