Home Page
|
What's New
|
Photos
|
Histories
|
Headstones
|
Reports
|
Surnames
Search
First Name:
Last Name:
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Suomalainen
Svenska
Elizabeth Edney
1537 - 1597 (60 years)
Submit Photo / Document
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Submit Photo / Doc
Worksheet
Family
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Elizabeth Edney
[1]
b. 28 Jun 1537 d. 28 Jun 1597
Robert Bennett
b. 10 Jul 1533 d. 19 Sep 1603
2
Johan Bennett
[1.1]
c. 1588 d. 8 Jul 1568
William Thomas
b. 1565 d. Aug 1639
3
Elizabeth Thomas
[1.1.1]
b. 7 Oct 1590 d. 27 Jun 1630
2
Margery Bennett
[1.2]
c. 25 Mar 1560 d. 1588
+
John Soule
b. Abt 1558 d. 1620
2
John Bennett
[1.3]
c. 22 Apr 1561 bur. 29 May 1651
2
Elizabeth Bennett
[1.4]
c. 31 May 1562 d. 12 Jul 1637
+
John Stephen Fry Pearce
b. Abt 1560
2
Agnes Bennett
[1.5]
c. 1 Aug 1563 d. 2 Aug 1598
John Godfrey
c. 15 Mar 1570 d. 18 Apr 1610
3
Agnes Ann Godfrey
[1.5.1]
b. 1592 d. 15 Aug 1662
John Wheeler
b. 4 Nov 1591 d. 29 Aug 1670
4
Joseph Wheeler
[1.5.1.1]
b. 17 Jan 1613 d. 13 Oct 1659
4
Adam Wheeler
[1.5.1.2]
b. 5 Dec 1616 d. 28 Mar 1688
4
Elizabeth Wheeler
[1.5.1.3]
b. 10 Jan 1618 d. 16 Jun 1696
Thomas Durston
b. 28 Oct 1627 d. 1 Jul 1662
5
Mary Duston
[1.5.1.3.1]
b. 1649 d. 1650
5
Thomas Durston
[1.5.1.3.2]
b. Abt 1652 d. 17 Nov 1732
Hannah Webster Emerson
b. 23 Dec 1657 d. 6 Mar 1738
6
Hannah Susannah Duston
[1.5.1.3.2.1]
b. 22 Aug 1678 d. 27 Nov 1768
6
Mary Dustin
[1.5.1.3.2.2]
b. 4 Nov 1681 d. 18 Oct 1696
6
Nathaniel Duston
[1.5.1.3.2.3]
b. 16 May 1685 d. 17 Feb 1762
6
Abigail Dustin
[1.5.1.3.2.4]
b. Oct 1690 d. 5 May 1727
6
Jonathan Durston
[1.5.1.3.2.5]
b. 15 Jan 1691 d. 1757
Elizabeth Watts
b. 31 Aug 1689 d. 25 Nov 1721
7
Mehitable Page Dustin
[1.5.1.3.2.5.1]
b. 8 Aug 1715 d. 29 Sep 1740
Jonathon Marsh
b. 15 Jun 1700 d. 26 May 1776
8
Mehitable Marsh
[1.5.1.3.2.5.1.1]
b. 14 Apr 1738 d. 4 Feb 1825
8
Miriam Marsh
[1.5.1.3.2.5.1.2]
b. 30 Jun 1740 d. 7 Jul 1823
Thomas Haynes
b. 23 Jul 1735 d. 26 Nov 1789
9
Samuel Haynes
[1.5.1.3.2.5.1.2.1]
b. 1 Mar 1763 d. 1800
9
Jonathan Haynes
[1.5.1.3.2.5.1.2.2]
b. 4 Jan 1765 d. 1833
9
Elizabeth Haynes
[1.5.1.3.2.5.1.2.3]
b. 16 Apr 1767 d. 1792
9
William Haynes
[1.5.1.3.2.5.1.2.4]
b. 30 Sep 1769 d. 1804
Mary Stoddard
b. 7 Apr 1776
10
Daphne Haynes
[1.5.1.3.2.5.1.2.4.1]
b. 29 Aug 1797 d. 29 Aug 1846
Isaiah Hamblin
b. 20 Jun 1790 d. 6 Oct 1856
11
Emily Haynes Hamblin
[1.5.1.3.2.5.1.2.4.1.1]
b. 31 Aug 1816 d. 4 Jul 1845
11
Jacob Hamblin
[1.5.1.3.2.5.1.2.4.1.2]
b. 2 Apr 1819 d. 31 Aug 1886
Lucinda Taylor
b. 24 Aug 1823 d. 1858
12
Duane Hamblin
[1.5.1.3.2.5.1.2.4.1.2.1]
b. 11 Jan 1841 d. 17 Dec 1862
12
Martha Adeline Hamblin
[1.5.1.3.2.5.1.2.4.1.2.2]
b. 15 Sep 1842 d. 17 Jun 1877
12
Maryette Magdaline Hamblin
[1.5.1.3.2.5.1.2.4.1.2.3]
b. 14 May 1845 d. 9 Mar 1910
12
Lyman Stoddard Hamblin
[1.5.1.3.2.5.1.2.4.1.2.4]
b. 11 Nov 1848 d. 23 Sep 1923
Rachel Judd
b. 15 Sep 1821 d. 18 Feb 1865
12
Lois Hamblin
[1.5.1.3.2.5.1.2.4.1.2.5]
b. 15 Jun 1851 d. 30 Aug 1891
12
Susan Hamblin
[1.5.1.3.2.5.1.2.4.1.2.6]
b. Abt 1854 d. 1862
12
Joseph Hamblin
[1.5.1.3.2.5.1.2.4.1.2.7]
b. 6 Oct 1854 d. 3 Dec 1924
12
Ellen Hamblin
[1.5.1.3.2.5.1.2.4.1.2.8]
b. Abt 1856 d. 17 Mar 1877
12
Rachel Tamar Hamblin
[1.5.1.3.2.5.1.2.4.1.2.9]
b. 3 Aug 1856 d. 17 Mar 1877
12
Benjamin Hamblin
[1.5.1.3.2.5.1.2.4.1.2.10]
b. 29 Sep 1858 d. 27 Sep 1930 [
=>
]
12
Arminda Hamblin
[1.5.1.3.2.5.1.2.4.1.2.11]
b. 27 Jan 1861 d. 1862
Sarah Priscilla Leavitt
b. 8 May 1841 d. 23 Jul 1927
12
Sarah Olive Hamblin
[1.5.1.3.2.5.1.2.4.1.2.12]
b. 15 Oct 1858 d. 30 Jun 1919
12
Melissa Hamblin
[1.5.1.3.2.5.1.2.4.1.2.13]
b. 25 Apr 1861 d. 9 May 1933
12
Lucy Hamblin
[1.5.1.3.2.5.1.2.4.1.2.14]
b. 11 May 1863 d. 28 Dec 1871
12
Jacob Vernon Hamblin, Jr.
[1.5.1.3.2.5.1.2.4.1.2.15]
b. 21 Mar 1865 d. 1 Apr 1939
12
Ella Ann Hamblin
[1.5.1.3.2.5.1.2.4.1.2.16]
b. 11 Jun 1867 d. 31 Mar 1947
12
Mary Elizabeth Hamblin
[1.5.1.3.2.5.1.2.4.1.2.17]
b. 25 Sep 1872 d. 12 May 1959
12
Clara Melvina Hamblin
[1.5.1.3.2.5.1.2.4.1.2.18]
b. 5 Nov 1876 d. 27 Jun 1959
12
Dudley Jabez Hamblin
[1.5.1.3.2.5.1.2.4.1.2.19]
b. 5 May 1880 d. 29 Jul 1968
12
Don Carlos Hamblin
[1.5.1.3.2.5.1.2.4.1.2.20]
b. 16 Feb 1882 d. 15 Nov 1941
Louise Bonelli
b. 28 Oct 1843 d. 11 Dec 1931
12
Walter Eugene Hamblin
[1.5.1.3.2.5.1.2.4.1.2.21]
b. 15 Apr 1868 d. 27 Jan 1950
12
Inez Louisa Hamblin
[1.5.1.3.2.5.1.2.4.1.2.22]
b. 4 Apr 1871 d. 4 Mar 1933
12
George Oscar Hamblin
[1.5.1.3.2.5.1.2.4.1.2.23]
b. 25 Mar 1873 d. 1 Sep 1946
12
Alice Edna Hamblin
[1.5.1.3.2.5.1.2.4.1.2.24]
b. 9 Feb 1876 d. 1 Mar 1902
12
Willard Otto Hamblin
[1.5.1.3.2.5.1.2.4.1.2.25]
b. 25 Mar 1881 d. 16 Sep 1967
12
Amarilla Hamblin
[1.5.1.3.2.5.1.2.4.1.2.26]
b. 4 May 1884 d. 14 Mar 1982
11
Olive Haynes Hamblin
[1.5.1.3.2.5.1.2.4.1.3]
b. 1 May 1821 d. 9 Jul 1839
11
Adeline Amarilla Hamblin
[1.5.1.3.2.5.1.2.4.1.4]
b. 18 Sep 1823 d. 20 Jul 1895
11
Obed Hamblin
[1.5.1.3.2.5.1.2.4.1.5]
b. 25 Feb 1826 d. 1848
11
Alsen Haynes Hamblin
[1.5.1.3.2.5.1.2.4.1.6]
b. 28 Apr 1828 d. 11 Aug 1862
11
William Haynes Hamblin
[1.5.1.3.2.5.1.2.4.1.7]
b. 25 Oct 1830 d. 8 May 1872
11
Oscar Hamblin
[1.5.1.3.2.5.1.2.4.1.8]
b. 3 Apr 1833 d. 8 Nov 1862
11
Edwin Hamblin
[1.5.1.3.2.5.1.2.4.1.9]
b. 20 May 1835 d. 12 Jan 1925
11
Francis Marion Hamblin
[1.5.1.3.2.5.1.2.4.1.10]
b. 27 Nov 1839 d. 30 Jul 1881
11
Frederick Hamblin
[1.5.1.3.2.5.1.2.4.1.11]
b. 12 Feb 1841 d. 8 Nov 1922
10
Alson Haynes
[1.5.1.3.2.5.1.2.4.2]
b. 1801
10
Emily Jane Haynes
[1.5.1.3.2.5.1.2.4.3]
b. 1803
9
Mahetabel Haynes
[1.5.1.3.2.5.1.2.5]
b. 23 Mar 1772 d. 31 Jan 1776
9
Elijah Haynes
[1.5.1.3.2.5.1.2.6]
b. 31 May 1774 d. 17 Sep 1806
9
Lee Haynes
[1.5.1.3.2.5.1.2.7]
b. 7 Jan 1777 d. 15 Feb 1777
9
Hulda A Haynes
[1.5.1.3.2.5.1.2.8]
b. 13 Jan 1779 d. 2 Apr 1807
9
Moses Haynes
[1.5.1.3.2.5.1.2.9]
b. 26 Jun 1780 d. 1 Mar 1818
9
Miriam Haynes
[1.5.1.3.2.5.1.2.10]
b. 1783 bur. Mar 1824
7
Hannah Dustin
[1.5.1.3.2.5.2]
b. 8 May 1717 bur. Jul 1825
7
Jonathan Dustin
[1.5.1.3.2.5.3]
b. 4 Jul 1719 d. 4 Jul 1812
7
David Dustin
[1.5.1.3.2.5.4]
b. 30 Jan 1721 d. 1784
7
Elizabeth Duston
[1.5.1.3.2.5.5]
b. 11 Jun 1724
6
Martha Duston
[1.5.1.3.2.6]
b. 9 Mar 1697 d. 15 Mar 1697
6
Lydia Duston
[1.5.1.3.2.7]
b. 4 Oct 1698 d. Abt 1764
4
Ann Wheeler
[1.5.1.4]
b. 13 May 1620 d. 19 May 1688
4
William Wheeler
[1.5.1.5]
b. 18 Sep 1623 d. Aft Mar 1668
4
David Wheeler
[1.5.1.6]
b. 18 Jan 1625 d. 1669
Sarah Wise
b. 1625 d. 13 Jan 1707
5
Sarah Wheeler
[1.5.1.6.1]
b. 1652 d. 24 Oct 1732
John Spofford
b. 24 Oct 1648 d. 24 Apr 1697
6
John Spofford
[1.5.1.6.1.1]
b. 24 Jun 1678 d. 11 Oct 1735
Dorcas Hopkinson
b. 18 Dec 1676 d. 2 May 1717
7
Francis Spafford
[1.5.1.6.1.1.1]
b. 19 Feb 1700 d. 15 Aug 1785
7
John Spofford
[1.5.1.6.1.1.2]
b. 19 Mar 1704 d. 1740
Hannah Tyler
b. 13 Jun 1714 d. Bef 1756
8
Bradstreet Spofford
[1.5.1.6.1.1.2.1]
b. 2 Sep 1731 d. 2 Dec 1808
8
Phebe Spofford
[1.5.1.6.1.1.2.2]
b. 1 Jul 1733
John Grout, Jr
b. 13 Jun 1731 d. Aft 1779
9
Phebe Grout
[1.5.1.6.1.1.2.2.1]
b. 21 Mar 1751 d. 1819
Jacob Winn
b. 20 Oct 1744
10
Augustus Winn
[1.5.1.6.1.1.2.2.1.1]
b. 18 Dec 1769 d. 24 Jun 1785
10
Lucend Winn
[1.5.1.6.1.1.2.2.1.2]
b. 12 Mar 1771
10
Phebe Winn
[1.5.1.6.1.1.2.2.1.3]
b. 7 Feb 1773 d. 23 May 1809
10
Endymia Winn
[1.5.1.6.1.1.2.2.1.4]
b. 1775 d. 1794
Thomas Sherwood
b. 1757 d. Abt 1844
11
Lucinda Sherwood
[1.5.1.6.1.1.2.2.1.4.1]
b. 13 Oct 1794 d. 7 Apr 1854
John Minthorn
b. 4 Oct 1768 d. 17 Dec 1859
12
Mary Minthorn
[1.5.1.6.1.1.2.2.1.4.1.1]
b. Aft 1812 d. Aft 1828
12
George Minthorn
[1.5.1.6.1.1.2.2.1.4.1.2]
b. Abt 1814 d. Aft 1847
12
Theodore Minthorn
[1.5.1.6.1.1.2.2.1.4.1.3]
b. 11 Oct 1817 d. 5 Oct 1866 [
=>
]
12
Jane Minthorn
[1.5.1.6.1.1.2.2.1.4.1.4]
b. Abt 1820 d. Aft 1834
11
Thomas Sherwood
[1.5.1.6.1.1.2.2.1.4.2]
b. 1797 d. 1865
9
Elijah Grout
[1.5.1.6.1.1.2.2.2]
b. 26 Jan 1753
9
Susannah Grout
[1.5.1.6.1.1.2.2.3]
b. 12 Dec 1754
9
Endymia Grout
[1.5.1.6.1.1.2.2.4]
b. 23 Dec 1756 d. 24 Apr 1759
9
Theodore Grout
[1.5.1.6.1.1.2.2.5]
b. 23 Aug 1759
9
Endymia Grout
[1.5.1.6.1.1.2.2.6]
b. 5 Aug 1761
9
John Butler Grout
[1.5.1.6.1.1.2.2.7]
b. 28 Apr 1763
9
Ferdinand Grout
[1.5.1.6.1.1.2.2.8]
b. 5 May 1765
9
Theodore Grout
[1.5.1.6.1.1.2.2.9]
b. 1 Feb 1767 d. 1831
9
Frederica Grout
[1.5.1.6.1.1.2.2.10]
b. 1 Dec 1768
9
Margaret Bradstreet Grout
[1.5.1.6.1.1.2.2.11]
b. 10 Apr 1771
8
Asa Spofford
[1.5.1.6.1.1.2.3]
b. 30 Jan 1736 d. 12 Feb 1738
8
Abigail Spofford
[1.5.1.6.1.1.2.4]
b. 26 Mar 1738
8
Relief Spafford
[1.5.1.6.1.1.2.5]
b. 30 Jun 1744 d. Oct 1758
8
Harriet Spofford
[1.5.1.6.1.1.2.6]
b. 30 Jan 1747
8
Job Tyler Spofford
[1.5.1.6.1.1.2.7]
b. 14 Mar 1747/1748 d. 15 Jun 1750
8
Tyler Spofford
[1.5.1.6.1.1.2.8]
b. 28 Apr 1752 d. 1844
7
Abner Spofford
[1.5.1.6.1.1.3]
b. 21 Aug 1705 d. 12 Sep 1777
7
Sarah Spofford
[1.5.1.6.1.1.4]
b. 27 Feb 1706 d. 10 Sep 1780
7
Dorcas Spofford
[1.5.1.6.1.1.5]
b. Abt 1709 d. 6 Aug 1784
6
Mary Spofford
[1.5.1.6.1.2]
b. 4 May 1680 d. 1750
6
David Spofford
[1.5.1.6.1.3]
b. 23 Nov 1681 d. 8 Aug 1717
6
Martha Spofford
[1.5.1.6.1.4]
b. 16 May 1687 d. 9 Nov 1730
6
Sarah Spofford
[1.5.1.6.1.5]
b. 16 May 1687 d. Abt 1760
6
Ebenezer Spofford
[1.5.1.6.1.6]
b. 14 Jun 1690 d. 29 Jun 1690
6
Nathaniel Spofford
[1.5.1.6.1.7]
b. 10 Sep 1691 d. 24 Feb 1692
5
Abigail Wheeler
[1.5.1.6.2]
b. 2 Feb 1655 d. 13 Apr 1742
5
Jonathan Wheeler
[1.5.1.6.3]
b. 6 Jan 1657 d. 12 Aug 1720
5
Nathan Wheeler
[1.5.1.6.4]
b. 27 Dec 1659 d. Bef 26 Jul 1741
5
Lidya Wheeler
[1.5.1.6.5]
b. 7 May 1662 d. 1719
5
Jethro Wheeler
[1.5.1.6.6]
b. 1664 d. 1725
Hannah French
b. 30 Jan 1670 d. 11 Mar 1717
6
Jethro Wheeler
[1.5.1.6.6.1]
b. 19 Aug 1692
6
Benjamin Wheeler
[1.5.1.6.6.2]
b. 23 May 1694 d. 1 Jan 1779
6
Moses Wheeler
[1.5.1.6.6.3]
b. Abt 1700 d. 23 Feb 1789
6
Abigail Wheeler
[1.5.1.6.6.4]
b. 1702
6
John Wheeler
[1.5.1.6.6.5]
b. 1710
5
Benjamin Wheeler
[1.5.1.6.7]
b. 21 Apr 1666 d. Abt 1690
5
Son Wheeler
[1.5.1.6.8]
b. 2 Apr 1668 d. 1668
5
Joseph Wheeler
[1.5.1.6.9]
b. 15 Sep 1669 d. 18 Oct 1705
4
Mercy Wheeler
[1.5.1.7]
b. 2 Feb 1627 d. Aft Mar 1668
4
Roger Wheeler
[1.5.1.8]
b. 20 Feb 1631 d. 7 Dec 1661
4
Henry Wheeler
[1.5.1.9]
b. 8 Feb 1633 d. 1696
2
Dorothy Bennett
[1.6]
b. 29 Aug 1564 d. 1 Jan 1603
2
Joan Bennett
[1.7]
c. 1 Mar 1566 d. 17 Oct 1601
2
Eleanor Bennett
[1.8]
c. 5 Mar 1568
Richard Harris
b. Abt 1569 d. 1630
3
William Harris
[1.8.1]
c. 28 Jan 1595
2
Thomas Bennett
[1.9]
c. 2 Apr 1570 d. 26 Sep 1616
Alice Anstie Tompson
b. 1579 d. 1647
3
Robert Bennett
[1.9.1]
c. 1 Feb 1602 d. 1648
3
Thomas Bennett, Jr
[1.9.2]
c. 5 Nov 1603 d. 23 Dec 1668
Agnes Beard
b. 23 Dec 1608
4
John Bennett
[1.9.2.1]
c. 10 Jul 1624 d. Aft 1670
Mary Berry
b. Abt 1628 d. 1667
5
Robert Bennett
[1.9.2.1.1]
b. Abt 1656 d. 18 Feb 1684
Mary Smith
b. 1660 d. 1686
6
Thomas Bennett
[1.9.2.1.1.1]
b. 20 Mar 1685 d. 3 Jan 1763
5
William Bennett
[1.9.2.1.2]
b. Abt 1659 d. 18 Feb 1684
Mary Smith
b. 1663 d. 1686
6
William Bennett
[1.9.2.1.2.1]
b. Abt 1684 d. 1710
Sarah Brumwell
c. 2 Nov 1679 d. 1720
7
William Peter Bennett
[1.9.2.1.2.1.1]
b. 2 Jun 1703 d. Aft 24 Jul 1777
Mary Humphries
b. 24 Jan 1703 d. 6 Feb 1733
8
Peter Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.1]
b. 21 Jun 1724 d. Jan 1778
8
Eliza Bennet
[1.9.2.1.2.1.1.2]
b. 1 Dec 1724
8
Elizabeth Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.3]
b. 1 Dec 1726
8
William Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.4]
b. 16 Dec 1727 d. Abt 1800
8
Joseph Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5]
b. 2 May 1731 d. 23 Apr 1837
Zipporah Whipple
b. 17 Mar 1757 d. 12 Mar 1810
9
Ralph Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.1]
b. 1778
9
Alfred Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.2]
b. 1780 d. 10 Mar 1861
9
Varney Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.3]
b. 1782
9
Zeporah Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.4]
b. 1783
9
Joseph Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.5]
b. 11 Sep 1788
Lucina Bonny
b. 28 Aug 1792
10
Louisa Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.1]
b. 8 Jun 1813 d. 31 Oct 1879
Abner Augustus Ames
b. 23 Nov 1799 d. 26 Sep 1850
11
Ralph Franklin Ames
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.1.1]
b. 28 Aug 1835 d. 19 Jan 1919
Tirzah A Chappel
b. 22 Aug 1824 d. 7 Jan 1863
12
John Chappel Ames
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.1.1.1]
b. 27 Dec 1857
12
Anna Louisa Ames
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.1.1.2]
b. 23 Jul 1859 d. 1918 [
=>
]
Eunice Marie Biglow
b. 1 Jan 1846 d. 31 Oct 1937
12
Mary Samantha Ames
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.1.1.3]
b. 14 Dec 1864 d. 23 Oct 1928 [
=>
]
12
William H Ames
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.1.1.4]
b. 29 Sep 1865 d. 2 Feb 1894 [
=>
]
12
Maria Ames
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.1.1.5]
b. 5 Feb 1869 d. 1942
12
Catherine Marie Ames
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.1.1.6]
b. 5 Feb 1869 d. 1938 [
=>
]
12
Margaret Mae Ames
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.1.1.7]
b. 6 May 1872 d. 5 Aug 1913 [
=>
]
12
Ralph Franklin Ames, Jr
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.1.1.8]
b. 23 Jun 1876 d. 1952 [
=>
]
12
Harry Ames
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.1.1.9]
b. 27 Feb 1880
12
Cora Ames
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.1.1.10]
b. 27 Feb 1880 d. 28 Mar 1888
12
Rex Gordon Ames
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.1.1.11]
b. 15 Jun 1884 d. May 1968
12
Jessie V Ames
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.1.1.12]
b. 6 Sep 1886 d. 20 Oct 1886
12
Lowell Harmon Ames
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.1.1.13]
b. 26 Jan 1890 d. 21 Sep 1961
11
Mary Elizabeth Ames
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.1.2]
b. 21 Dec 1839 d. 21 Jan 1911
James Osborne
b. 24 Apr 1830 d. 21 Dec 1900
12
William A Osborne
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.1.2.1]
b. 15 Aug 1858
12
Charles H Osborne
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.1.2.2]
b. Mar 1860 d. 1933
12
Olive Aurora Osborne
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.1.2.3]
b. 12 Apr 1862 d. 26 Oct 1944 [
=>
]
12
Joseph V Osborne
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.1.2.4]
b. 20 Mar 1864 d. 1938
11
Janette Clarissa Ames
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.1.3]
b. 19 Aug 1841 d. Sep 1903
Alexander Osburn
b. 1827 d. 4 May 1881
12
Adella May Osburn
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.1.3.1]
b. Apr 1864 d. 29 Jan 1923 [
=>
]
12
William Welcome Osburn
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.1.3.2]
b. 1866 d. 3 Sep 1919 [
=>
]
12
John W Osburn
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.1.3.3]
b. 10 May 1882 d. 12 Feb 1945 [
=>
]
11
Joseph Van Harmon Ames
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.1.4]
b. 22 Sep 1844 d. 1 May 1862
11
Olive Aurora Ames
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.1.5]
b. 22 Sep 1844 d. Apr 1849
11
Augustus Ames
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.1.6]
b. 1848 d. 1850
11
Jane Evaline Ames
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.1.7]
b. 1849 d. 1850
10
Lucinda A Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.2]
b. 16 May 1816 d. 14 Jun 1903
Charles Putnum
b. 24 Mar 1810 d. 16 Mar 1892
11
Lubin Augustus Putnam
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.2.1]
b. 1838
Mary Melissa Chase
b. 1849
12
Welie Lusina Putnam
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.2.1.1]
b. 30 Dec 1870
+
Lucina Hand
b. 1840 d. 29 Jan 1882
11
Fernando Cortez Putnum
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.2.2]
b. 28 Feb 1844 d. 29 Sep 1913
Abbie Bogue
b. 12 Sep 1859 d. 20 Jul 1931
12
Floyd Alger Putnam
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.2.2.1]
b. 8 Jan 1887 d. Apr 1977
12
Ruth Lois Putnam
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.2.2.2]
b. 13 Oct 1888 d. 12 May 1968 [
=>
]
12
Helen O Putnam
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.2.2.3]
b. 10 Aug 1890
12
Alma Putman
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.2.2.4]
b. 6 Oct 1893
12
Olive Putnum
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.2.2.5]
b. 6 Oct 1893 d. May 1984
12
Marion E Putnum
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.2.2.6]
b. 9 Jul 1899 d. Sep 1973
12
Arthur Truman Putnam
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.2.2.7]
b. 1906 d. 9 Oct 1906
11
Charles C Putnum
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.2.3]
b. 13 May 1845 d. 2 Jan 1921
11
Elwood Putman
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.2.4]
b. 1849
11
Daniel Putnum
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.2.5]
10
George H Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.3]
b. 30 Mar 1818 d. 22 Oct 1886
Aurora Richardson
b. 1821 d. 17 Jun 1887
11
Son Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.3.1]
b. Abt 1846
11
Miranda Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.3.2]
b. Abt 1846 d. Abt 1865
11
Son Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.3.3]
b. 1848
10
Joseph Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.4]
b. 13 Jul 1819 d. 11 Apr 1883
+
Eliza
b. 1810 d. 20 Apr 1883
10
Varney E Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.5]
b. 10 Oct 1820 d. 6 Mar 1896
Jane Herrick
b. 15 Jun 1821 d. 24 Mar 1893
11
Dell Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.5.1]
b. 1848 d. 1918
Samantha Bennett
b. 1856 d. 1943
12
George Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.5.1.1]
b. 1877
12
Addie M Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.5.1.2]
b. 1879 [
=>
]
12
Dennis E Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.5.1.3]
b. 17 May 1887
11
Jackson Adelbert Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.5.2]
b. 24 Dec 1850 d. 12 Sep 1938
Josephine Augusta Cady
b. 7 Dec 1851 d. 28 Apr 1912
12
Harry Robinson Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.5.2.1]
b. 13 Sep 1872 d. 9 Sep 1944 [
=>
]
12
Otis Earl Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.5.2.2]
b. 18 Feb 1884 d. 13 Jan 1926 [
=>
]
11
Elwood Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.5.3]
b. 3 Jan 1851 d. 30 Jun 1890
+
Mary Jane Milne
b. 1852 d. 23 May 1887
Onna Idzinga
b. 16 Mar 1869 d. 6 Feb 1920
12
Eva Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.5.3.1]
b. 7 Jun 1888 d. Dec 1970
12
Jessie Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.5.3.2]
b. 11 Oct 1889
11
Alfred Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.5.4]
b. 1857
+
Alice Fisher
b. 1876
11
Anna Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.5.5]
b. 1863
11
Gifford Allen Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.5.6]
b. 10 Jan 1863 d. 27 Jun 1916
Marcia C Nichols
b. 6 Feb 1856 d. 21 Jul 1936
12
Josephine Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.5.6.1]
b. Nov 1891
12
Harry E Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.5.6.2]
b. 4 Oct 1894 d. 6 Oct 1984 [
=>
]
11
Dennis H Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.5.7]
d. 9 Jan 1940
Emma Jenkins
12
Nellie Ann Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.5.7.1]
b. 1895
10
Sophia Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.6]
b. 17 Jun 1822
10
Josiah Hibbard Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.7]
b. 12 Jul 1824 d. 8 Mar 1904
10
Truman Sherman Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.8]
b. 28 Mar 1826 d. 26 Mar 1899
Huldah Edson
b. 26 Aug 1831 d. 6 Sep 1876
11
Horatio Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.8.1]
b. 26 May 1850 d. 1850
11
Ezra T Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.8.2]
b. 1 Jun 1851 d. 1851
11
Walter Ancil Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.8.3]
b. 11 May 1854 d. 27 Feb 1926
Emily Ida Bunker
b. 14 Jan 1852 d. 18 Sep 1913
12
Martha Elizabeth Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.8.3.1]
b. 27 Jul 1878
12
Charles Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.8.3.2]
b. 1880
12
Perez Nathaniel Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.8.3.3]
b. 8 Apr 1883
12
Winifred Isabelle Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.8.3.4]
b. 7 Jan 1889 d. 3 Apr 1974
+
Alice Elnora Altice
b. 1849
11
Evaline Viola Bennet
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.8.4]
b. 24 Jan 1859 d. 20 May 1943
Sylvaneus M Turner
b. 2 Aug 1852 d. 30 Jan 1924
12
Grace H Turner
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.8.4.1]
b. 11 Sep 1876 d. 17 Sep 1943 [
=>
]
12
Lucy Eveline Turner
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.8.4.2]
b. 1879 d. 1974 [
=>
]
12
Clara Gertrude Turner
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.8.4.3]
b. Abt 1879 d. 1885
12
Wellman Ellery Turner
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.8.4.4]
b. 20 Sep 1881 d. 7 Mar 1953 [
=>
]
12
Truman Herbert Turner
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.8.4.5]
b. 14 Oct 1882 d. 1933 [
=>
]
12
Ernest S Turner
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.8.4.6]
b. Aug 1884
12
Permilla A Turner
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.8.4.7]
b. Sep 1886
12
Rexford Archibald Turner
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.8.4.8]
b. 30 Oct 1887 [
=>
]
11
Wellman George Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.8.5]
b. 28 May 1862 d. 21 Feb 1898
Addie Rose Willey
b. 26 Nov 1867 d. 23 Oct 1955
12
Mabel Evelyn Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.8.5.1]
b. 28 Oct 1889 d. 1953 [
=>
]
12
Gardner Byron Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.8.5.2]
b. 21 Dec 1889 d. 17 Sep 1956 [
=>
]
12
Clifton L Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.8.5.3]
b. 12 Oct 1891 d. Oct 1976
12
Ethel Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.8.5.4]
b. 3 Aug 1893 d. May 1928
11
Dolly Arluine Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.8.6]
b. 25 Sep 1865 d. 1 Jan 1899
George B Olmstead
b. 2 Oct 1861 d. 16 Feb 1943
12
Willard Russell Olmstead
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.8.6.1]
b. 16 Sep 1884 d. 28 Mar 1920 [
=>
]
12
Francis Walter Olmstead
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.8.6.2]
b. 23 Dec 1885 d. 27 Aug 1963 [
=>
]
12
Nathanial R Olmstead
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.8.6.3]
b. 21 Nov 1888 d. 27 Jun 1946 [
=>
]
12
Ralph Ellery Olmstead
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.8.6.4]
b. 30 Sep 1891 d. Nov 1979 [
=>
]
12
Floyd Ezra Olmstead
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.8.6.5]
b. 13 Jun 1893 d. 15 May 1961 [
=>
]
12
Eda Arluine "Edith" Olmstead
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.8.6.6]
b. 9 May 1895 d. May 1985
11
Lowell E Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.8.7]
b. 1 Jun 1868
10
Hannah Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.5.9]
b. 15 Jun 1829
9
Thankful Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.6]
b. 1791
9
William Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7]
b. 1795 d. 23 Jun 1863
Lydia Caryl
b. 24 Jan 1797 d. 1868
10
William Bennett, Jr
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.1]
b. Jan 1822 d. 1904
Hannah Jane Kibbe
b. 16 Sep 1832
11
Raymond A Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.1.1]
b. 12 Jan 1853 d. 6 Sep 1921
+
Anna Belle Noble
b. Apr 1866
11
Finley Anson Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.1.2]
b. Aug 1854
11
Elva Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.1.3]
b. 1857
Daniel Spencer
12
Tuphina Spencer
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.1.3.1]
b. 23 Dec 1873
11
Ada Fidelia Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.1.4]
b. 1861
David William Smith
b. 26 Dec 1853 d. 23 Aug 1917
12
Willliam Henry Smith
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.1.4.1]
b. 2 Feb 1880 d. May 1981 [
=>
]
11
Emma Jane Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.1.5]
b. 10 Mar 1862 d. 25 Sep 1931
11
Henry E Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.1.6]
b. 1864 d. 1895
Hattie Helen Jackson
b. 1870
12
Henry M Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.1.6.1]
b. 6 Nov 1891
12
Eva Maude Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.1.6.2]
b. 21 Jun 1894
11
Louisa Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.1.7]
b. 16 May 1870 d. 1930
10
Alonzo Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.2]
b. 10 Nov 1824 d. 2 Oct 1884
+
Maryette Moore
b. Abt 1824
Margaret Maxwell
b. 25 Sep 1835 d. 27 May 1915
11
Willis Lugene Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.2.1]
b. 8 Mar 1858 d. 2 Jun 1924
Sarah Crosby "Sallie" Babbitt
b. Sep 1855 d. 29 Jul 1897
12
Winifred Elizabeth Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.2.1.1]
b. 16 Jan 1890 d. 7 May 1965 [
=>
]
12
George Russell Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.2.1.2]
b. 13 Feb 1893 d. 14 Sep 1893
+
Louiza Evelyn Smith
b. 10 Apr 1866 d. 6 Dec 1958
11
Nettie Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.2.2]
b. 1859
11
Alpha Alonzo Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.2.3]
b. 26 May 1860 d. 21 Dec 1931
Mary Belle Spencer
b. Oct 1868 d. 21 Jun 1932
12
Effie May Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.2.3.1]
b. 30 May 1887 d. 14 Jun 1894
12
Frederick Spencer Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.2.3.2]
b. 19 Jun 1893 d. 13 Jun 1972 [
=>
]
12
Forest Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.2.3.3]
b. 1897
12
David Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.2.3.4]
b. 1902
11
Effie May Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.2.4]
b. Abt May 1862 d. 10 Dec 1943
George Gilbert
b. 15 Feb 1858 d. 1939
12
Edith M Gilbert
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.2.4.1]
b. 27 Jan 1884 [
=>
]
12
Georgia Etta Gilbert
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.2.4.2]
b. Apr 1886 d. 22 Mar 1910 [
=>
]
12
George Gilbert
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.2.4.3]
b. Jan 1892 d. 26 Apr 1910
12
Emma Gilbert
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.2.4.4]
b. 16 Jan 1900
12
Treva Marguerite Gilbert
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.2.4.5]
b. 16 Jan 1900 d. 6 Feb 1992 [
=>
]
11
Margaret Emma Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.2.5]
b. 12 Aug 1862 d. 11 Jan 1915
William Henry Abell
b. 18 Oct 1855 d. 1 Feb 1916
12
Bert W Abell
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.2.5.1]
b. Oct 1877
12
Glenn Henry Abell
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.2.5.2]
b. 22 May 1880 d. 29 Aug 1906 [
=>
]
11
Albert D Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.2.6]
b. 1863 d. 19 May 1893
11
Dora Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.2.7]
b. 1866
11
Adelbert Glen Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.2.8]
b. 6 Sep 1869
Rose M Halstead
b. 26 Feb 1874 d. 14 Jul 1940
12
Lloyd Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.2.8.1]
b. 1894 d. 8 May 1896
12
Ovid Earl Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.2.8.2]
b. 10 Jun 1897 d. 18 Nov 1968 [
=>
]
11
Minnie Adora Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.2.9]
b. 21 May 1871 d. 26 Jul 1939
Merton Eugene Cobb
b. 20 Aug 1871 d. 28 Apr 1951
12
Minnie M Cobb
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.2.9.1]
b. 25 Aug 1894 d. 25 Aug 1894
12
Lila Pauline Cobb
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.2.9.2]
b. 23 Jul 1897 d. 17 Oct 1997 [
=>
]
12
Lloyd McKinley Cobb
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.2.9.3]
b. 28 Feb 1899 d. 31 May 1988
12
Reva L Cobb
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.2.9.4]
b. 13 Jul 1907 d. 1 Jun 1996
12
Rena M Cobb
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.2.9.5]
b. 13 Jul 1907 d. 22 Jan 1995
10
Anna Orpha Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.3]
b. 3 Sep 1826 d. 29 Aug 1909
Obed Rust
b. 22 Aug 1824 d. 30 Jun 1869
11
Caroline Rust
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.3.1]
b. 1848
11
Corodyne O Rust
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.3.2]
b. 26 Apr 1848 d. 27 Jun 1898
Ann L Baker
b. 5 Jan 1850 d. 16 May 1922
12
Luther Rust
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.3.2.1]
b. 13 Jul 1874
12
Bert Hart Rust
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.3.2.2]
b. 8 Jan 1877 d. 6 Jul 1945
12
Bertrand Rust
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.3.2.3]
b. 12 Feb 1877
12
Gertrude E Rust
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.3.2.4]
b. 21 Jan 1880 d. 3 Jun 1911 [
=>
]
12
Platt William Rust
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.3.2.5]
b. 19 Nov 1887 d. 1957 [
=>
]
11
Truman H Rust
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.3.3]
b. 1850
+
Kate L Weed
b. 1855
11
Eva L Rust
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.3.4]
b. 23 Dec 1852 d. 19 Aug 1911
+
Charles E Carroll
b. 1860
11
Ida A Rust
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.3.5]
b. 27 Sep 1855 d. 6 Feb 1892
Andrew J Carroll
b. 15 Apr 1854 d. 3 Mar 1917
12
Henry Willard Carroll
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.3.5.1]
b. 21 Jan 1878
12
Eva Maud Carroll
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.3.5.2]
b. 17 Oct 1879 d. 12 Dec 1911
12
Anna G Carroll
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.3.5.3]
b. 15 Mar 1888 d. 29 Jun 1909
11
Densie R Rust
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.3.6]
b. 20 Aug 1857
+
John H French
b. 28 Sep 1850 d. 23 Dec 1932
11
Carrie O Rust
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.3.7]
b. 20 Apr 1861 d. 9 Sep 1865
11
Harmon H Rust
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.3.8]
b. 1 May 1863 d. 3 Sep 1865
11
Ada W Rust
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.3.9]
b. 30 May 1865
11
Add W Rust
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.3.10]
b. 30 May 1865 d. 25 Sep 1919
+
Bertha V Baker
b. 1861
+
Margaret H Smith
b. 1856
11
Elisha D Rust
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.3.11]
b. 28 Oct 1868 d. 31 May 1929
Minnie E Brookins
b. Nov 1867
12
Olive Blanche Rust
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.3.11.1]
b. Feb 1898 d. 31 Mar 1991
12
Hubert M Rust
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.3.11.2]
b. Abt 1902 d. Aft 1991
12
Donald E Rust
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.3.11.3]
b. 13 Sep 1904 d. 19 Jul 1993
12
Hazel Rust
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.3.11.4]
b. 1906 d. Aft 1991
12
Hazel Rust
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.3.11.5]
b. 1907
12
Hudson Rust
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.3.11.6]
b. 1912
10
Arvilla Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.4]
b. Oct 1828 d. 28 Mar 1907
David C Hollis
b. Nov 1824 d. 9 Jun 1892
11
Albert A Hollis
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.4.1]
b. 6 Jun 1852 d. 11 Mar 1877
Jane Eliza Dudley
b. 5 Aug 1851 d. 6 Feb 1939
12
Harvey Albert Hollis
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.4.1.1]
b. 26 Dec 1874 d. 12 Oct 1876
12
Clanie B Hollis
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.4.1.2]
b. 24 Aug 1876
11
Flora M Hollis
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.4.2]
b. 19 Jul 1853 d. 30 Apr 1879
+
George Daniel Andrews
b. 8 Aug 1850 d. 2 Feb 1919
11
Nettie E Hollis
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.4.3]
b. Mar 1856 d. 21 Aug 1858
11
Willie W Hollis
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.4.4]
b. Mar 1860 d. 6 Apr 1862
11
Nellie Arvilla Hollis
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.4.5]
b. May 1863 d. 2 Dec 1941
Charles Emerson Walters
b. 12 Jun 1861 d. 24 Sep 1938
12
David Irwin Walters
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.4.5.1]
b. 17 Aug 1883 d. 29 Nov 1964
12
Arvilla Hannah Walters
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.4.5.2]
b. 26 Jun 1886 d. 18 Mar 1970 [
=>
]
10
Anson Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.5]
b. Nov 1830 d. 24 Apr 1905
Celia Eliza Durkee
b. 30 Apr 1838 d. 19 Mar 1926
11
John M Bennet
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.5.1]
b. Jun 1861 d. 10 Jun 1917
11
Lola M Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.5.2]
b. 1862 d. 20 Jun 1934
+
James T Calder
b. Abt 1857
11
Ernest O Bennet
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.5.3]
b. 11 Jul 1872 d. 15 May 1945
10
Maria Lydia Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.6]
b. 14 Nov 1832 d. 8 May 1916
Albert F Horton
b. 21 Jul 1828 d. 8 Dec 1914
11
Franklin S Horton
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.6.1]
b. 21 May 1855 d. 27 Jul 1935
Nora B Dana
b. 28 Feb 1865 d. 25 Apr 1912
12
Alice M Horton
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.6.1.1]
b. 20 Sep 1886
+
Myrtle Kitchen
b. Jul 1870
11
Herbert Henry Horton
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.6.2]
b. Mar 1863 d. 10 May 1918
Lydia Lindner
b. 19 Jul 1863 d. 1 Feb 1904
12
Eva May Horton
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.6.2.1]
b. 13 Jun 1884
12
Verna H Vanether
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.6.2.2]
b. 1886
12
Herbert H Horton
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.6.2.3]
b. May 1886 d. 1978 [
=>
]
12
Elizabeth Horton
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.6.2.4]
b. 1 May 1888 d. 2 Aug 1921 [
=>
]
12
Nellie Horton
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.6.2.5]
b. 14 Jul 1890 [
=>
]
12
Banker Horton
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.6.2.6]
b. 16 Mar 1893 [
=>
]
12
Bryan Horton
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.6.2.7]
b. Jul 1895
+
Mary Emma Herrick
b. 20 Mar 1865 d. 3 Jun 1938
11
Nora Horton
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.6.3]
b. 1866 d. 1957
Fred Tobias
b. 18 Mar 1863 d. 28 Sep 1932
12
Archie Bird Tobias
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.6.3.1]
b. 1889 d. Oct 1968
11
Albert F Horton, Jr
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.6.4]
b. 21 Feb 1868 d. 5 Jul 1938
+
Nancy Putman
b. 14 Jan 1872 d. 3 Sep 1902
11
Minnie Letty Horton
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.6.5]
b. 17 Dec 1869 d. 6 Jul 1964
+
George A Rix
b. 11 Oct 1873 d. 27 Oct 1951
11
Jennie A Horton
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.6.6]
b. Dec 1871 d. 1956
Guy Madison Litchfield
b. 27 May 1870 d. 1 Aug 1941
12
Florence Litchfield
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.6.6.1]
b. 29 May 1893 d. 19 Apr 1985
11
Floyd Myron Horton
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.6.7]
b. May 1874 d. 18 May 1949
+
Eliza Ray
b. 23 Dec 1876 d. 9 Jul 1928
10
Elvira C Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.7]
b. 20 Feb 1835 d. 4 Nov 1905
Daniel Harris Crowningshield
b. 28 Oct 1827 d. 30 Nov 1911
11
Cordine H Crowningshield
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.7.1]
b. 1867
11
Theda Elnora "Nora" Crowningshield
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.7.2]
b. 10 Nov 1870 d. 18 Jan 1949
George Henry Fahnestock
b. 28 Jan 1874 d. 30 Dec 1954
12
Dewey Fahnestock
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.7.2.1]
b. 29 Aug 1899 d. 8 Jan 1961
12
Clifford Roy Fahnstock
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.7.2.2]
b. 8 Oct 1901 d. 13 Nov 1981
12
Harold "Ike" Fahnestock
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.7.2.3]
b. 10 Jan 1905 d. Feb 1982
12
Floyd Hubert Fahnestock
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.7.2.4]
b. 22 Apr 1909 d. 15 Feb 1911
10
Simon Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.8]
b. 1839 d. 8 Oct 1902
Alice Minerva Maxwell
b. Oct 1846 d. 29 Aug 1908
11
Ambers Simon "Ambrose" Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.8.1]
b. 10 Dec 1864 d. 8 Feb 1932
Ellen K Ross
b. 11 Jun 1869 d. 19 Sep 1943
12
Hugh Lee Roy Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.8.1.1]
b. 1 Jul 1890 d. 14 Jan 1964
12
Carl Leslie Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.8.1.2]
b. 4 Aug 1895 d. 11 Nov 1966 [
=>
]
12
Grace Leona Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.8.1.3]
b. 1903 d. 7 Jul 1943
12
Ross Laverne Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.8.1.4]
b. 7 Apr 1906 d. 14 Nov 1973 [
=>
]
11
Minerva May "Minnie" Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.8.2]
b. 4 Jul 1866 d. 29 Oct 1954
Eugene Leonard Snell
b. 17 Jan 1862 d. 30 Apr 1949
12
Ola May Snell
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.8.2.1]
b. 1889 bur. Jun 1975 [
=>
]
12
Eva Lena Snell
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.8.2.2]
b. 23 Dec 1891
12
Otis R Snell
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.8.2.3]
b. 1894 d. 19 Feb 1985
12
Eldie S Snell
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.8.2.4]
b. 1896
12
Alice B Snell
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.8.2.5]
b. 1900 d. 20 Jul 1983
12
Caroline C "Carrie" Snell
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.8.2.6]
b. 1903
11
Cora M Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.8.3]
b. Jan 1868 d. 29 Feb 1908
+
George Lewis Friend
b. Jan 1868 d. 29 Feb 1908
11
Myrtle Louella "Marties" Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.8.4]
b. 13 Oct 1872 d. 5 Dec 1944
Fred L Euga
b. 8 Aug 1870 d. 16 Dec 1948
12
Vivian A Euga
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.8.4.1]
b. 1906 d. 1906
12
Ellen W Euga
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.8.4.2]
b. 1907 d. 1908
11
Llewellyn Merton "Mertie" Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.8.5]
b. 13 Oct 1872 d. 20 Dec 1940
11
William Henry Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.8.6]
b. 21 Sep 1875 d. 16 Mar 1925
Eda Altha Hockert
b. 13 Oct 1881 d. 31 Dec 1939
12
Dayton L Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.8.6.1]
b. 24 Jun 1903 d. 29 Nov 1903
12
Orba William Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.8.6.2]
b. 31 Dec 1904 d. 4 Aug 1912
12
Russell Ara Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.8.6.3]
b. 23 Feb 1906 d. 27 Dec 1943
12
Irene Genevieve Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.8.6.4]
b. 2 Jun 1907 d. 2001
12
Hazel May Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.8.6.5]
b. 2 Jun 1907 d. 2004
12
Lawrence Gilbert Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.8.6.6]
b. 6 May 1911 d. 2 Mar 1998
12
Altha Ione Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.8.6.7]
b. 13 Nov 1913 d. Jun 2009
12
Eda Alice Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.8.6.8]
b. 13 Oct 1915 d. 19 Dec 1939
12
Living
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.8.6.9]
12
Ruth Effie Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.7.8.6.10]
b. 1924 d. 2001
9
Polly Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.8]
b. 1797
9
Adin Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.9]
b. 1800 d. 6 May 1830
Angelina Houghton
b. 26 Aug 1801 d. 6 May 1891
10
Milo Pettibone Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.9.1]
b. 1821 d. 26 Feb 1844
10
Emery Seymoor Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.9.2]
b. 1823 d. 8 Dec 1825
10
Edwin Oscar Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.9.3]
b. 15 Dec 1824 d. 13 Sep 1901
10
Amelia Emeline Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.5.9.4]
b. 26 Oct 1827 d. 3 Feb 1918
Charles Parker
b. 1822 d. 25 Aug 1895
11
Esther Parker
[1.9.2.1.2.1.1.5.9.4.1]
b. 1849
11
Mary Angeline Parker
[1.9.2.1.2.1.1.5.9.4.2]
b. 3 May 1849 d. 14 Jun 1919
Albert Bingham Woodworth
b. 7 Apr 1843 d. 24 Jun 1908
12
Edward Knowlton Woodworth
[1.9.2.1.2.1.1.5.9.4.2.1]
b. 25 Aug 1875 d. 28 Sep 1938 [
=>
]
12
Grace Woodworth
[1.9.2.1.2.1.1.5.9.4.2.2]
b. Oct 1879
12
Charles Parker Woodworth
[1.9.2.1.2.1.1.5.9.4.2.3]
b. 8 Jul 1885 d. 16 Feb 1967 [
=>
]
11
Joseph Parker
[1.9.2.1.2.1.1.5.9.4.3]
b. 1851
11
Charles E Parker
[1.9.2.1.2.1.1.5.9.4.4]
b. 1851 d. 1852
11
Harry Elwood Parker
[1.9.2.1.2.1.1.5.9.4.5]
b. 11 Jun 1853 d. 12 May 1933
Anne Marie Weston
b. 4 Jun 1851 d. 26 Feb 1920
12
Leslie Wilson Parker
[1.9.2.1.2.1.1.5.9.4.5.1]
b. 26 Apr 1877 d. 28 Feb 1878
12
Katherine Louise Parker
[1.9.2.1.2.1.1.5.9.4.5.2]
b. 9 Jul 1879 d. 17 Oct 1945 [
=>
]
12
Sara Knowles Parker
[1.9.2.1.2.1.1.5.9.4.5.3]
b. 3 Dec 1881 d. 21 Apr 1952
12
Charles Parker
[1.9.2.1.2.1.1.5.9.4.5.4]
b. 1 Jul 1884 d. 27 Feb 1954 [
=>
]
12
Levi Houghton Parker
[1.9.2.1.2.1.1.5.9.4.5.5]
b. 5 Jan 1891 d. 8 Oct 1918 [
=>
]
11
Grace E A Parker
[1.9.2.1.2.1.1.5.9.4.6]
b. 29 Jun 1860
Thomas Julian Walker, Jr
b. 12 Mar 1856 d. 13 Jan 1911
12
Shirley Penn Walker
[1.9.2.1.2.1.1.5.9.4.6.1]
b. 19 Dec 1884 d. 31 Jul 1936 [
=>
]
12
Anne M Walker
[1.9.2.1.2.1.1.5.9.4.6.2]
b. 15 Sep 1886 d. Apr 1969
8
Richard Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.6]
b. 6 Feb 1732 d. 1786
Hannah Goad
b. 7 Apr 1725 d. 1770
8
Benjamin Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.7]
b. 1735 d. 1783
8
Thomas Fullalove Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.8]
b. 1742 d. 6 Feb 1809
8
Stephen Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.9]
b. 1744 d. 1826
8
Sarah Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.10]
b. 1744 d. 1805
8
James William Bennett
[1.9.2.1.2.1.1.11]
b. 25 Jun 1745 d. 21 May 1826
7
Peter Bennett
[1.9.2.1.2.1.2]
b. 7 Nov 1704 d. 12 Feb 1726
7
Elizabeth Bennett
[1.9.2.1.2.1.3]
c. 2 Mar 1707
7
Richard Bennett
[1.9.2.1.2.1.4]
c. 1 May 1709 d. 1786
Elizabeth Rice
b. Abt 1710 d. 1774
8
Rice Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1]
b. 1726 d. 24 Aug 1772
Sarah Hampton
b. 1733 d. 19 Sep 1796
9
Mary Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.1]
b. Abt 1753
9
William Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2]
b. Abt 1755 d. May 1823
Catherine Bernard
b. 1758 d. Feb 1831
10
Mary Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.1]
b. 6 Mar 1776 d. 16 Aug 1847
10
Elisha Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.2]
b. Abt 1777 d. Bef 14 Oct 1839
10
Elizabeth Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.3]
b. 23 Aug 1782
10
Richard Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.4]
b. 30 Mar 1785 d. 30 Aug 1835
+
Mary Bell
b. 5 Dec 1786 d. 12 Apr 1856
10
Martha Jane Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.5]
b. Abt 1786 d. 20 Oct 1871
10
Lucy Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.6]
b. Abt 1788 d. Aft 1850
10
William Junior Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7]
b. 22 Jul 1790 d. 1 Oct 1846
Elizabeth Bell
b. 4 Nov 1792 d. 5 Nov 1864
11
Austin Bell Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.1]
b. 11 Dec 1814 d. 8 Jul 1896
Angelina Storm
b. 8 Nov 1818 d. 25 Sep 1854
12
John J Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.1.1]
b. Abt 1839 [
=>
]
12
Eli Preston Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.1.2]
b. Abt 1840 [
=>
]
12
Sarah Ann Elizabeth Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.1.3]
b. 14 Aug 1842 d. 30 Apr 1934 [
=>
]
12
Adolphus J Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.1.4]
b. 1842
12
Samuel Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.1.5]
b. Abt 1847 d. Abt 1919 [
=>
]
12
William Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.1.6]
b. 1848 d. Bef 1896 [
=>
]
12
David L Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.1.7]
b. 14 Jun 1851 d. 13 Dec 1932
12
Vina J Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.1.8]
b. 1854 d. 6 Oct 1854
Lucretia Jane Aldridge
b. 8 Feb 1831 d. 5 Mar 1910
12
Mary Angeline Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.1.9]
b. 1857 [
=>
]
12
Thomas F Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.1.10]
b. 1860 d. Bef 1896
12
Eliza Jane Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.1.11]
b. 1862 [
=>
]
12
Hiram Washington Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.1.12]
b. 1866 d. 21 Jun 1910 [
=>
]
12
Patrick Henry Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.1.13]
b. 1869 d. 1946 [
=>
]
11
Thomas McGuire Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.2]
b. 24 Feb 1816 d. 24 Feb 1894
Sarah Bennett
b. 1815
12
Elizabeth E Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.2.1]
b. 22 Jan 1837 d. 2 May 1911 [
=>
]
12
Thomas J Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.2.2]
b. Nov 1839
12
Margaret F Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.2.3]
b. 1842
12
James Washington Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.2.4]
b. 25 Jul 1857 d. 25 Apr 1920 [
=>
]
Margaret Lavina Wilson
b. 22 Feb 1815 d. 30 Oct 1907
12
William Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.2.5]
b. 25 May 1849 d. 23 Aug 1904 [
=>
]
11
Sarah Ann Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.3]
b. 8 Oct 1817
11
Eliza Catherine Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.4]
b. 19 Jan 1819
Samuel Downes
b. 1830 d. 16 Jan 1894
12
Samuel Downes
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.4.1]
b. 1854
12
Elizabeth Downes
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.4.2]
b. 1856
12
Arthur Downes
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.4.3]
b. 1857 [
=>
]
12
Frederick Downes
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.4.4]
b. 1860
11
Mary Jane Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.5]
b. 1 Jan 1821 d. 25 Jun 1852
Jesse Temple McCauslin
b. 24 Feb 1817 d. 6 Mar 1884
12
William Y McCauslin
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.5.1]
b. Abt 1850 d. 8 Apr 1865
12
Sally McCauslin
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.5.2]
b. Abt 1848 d. 26 Jun 1852
11
Hiram Bell Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.6]
b. 1 Mar 1823 d. 17 Aug 1912
Martha Smith
b. 9 Jun 1817 d. 12 Oct 1902
12
Henry Bell Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.6.1]
b. Jun 1846 d. Jun 1846
12
Hyrum William Asahel Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.6.2]
b. 22 Nov 1848 d. 9 Jan 1849
12
Martha Eliza Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.6.3]
b. 24 Jan 1849 d. 6 May 1924 [
=>
]
12
Ezra Melanthorn Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.6.4]
b. 20 Oct 1851 d. 25 Aug 1852
12
Emily Jane Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.6.5]
b. 17 Jan 1854 d. 4 May 1903 [
=>
]
12
Elizabeth Emma Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.6.6]
b. 2 Jul 1856 d. 26 Feb 1940 [
=>
]
12
Elias Austin Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.6.7]
b. 26 Jan 1858 d. 1 May 1861
Ellen Greenhalgh
b. 27 Jul 1851 d. 4 May 1890
12
Jesse Johnson Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.6.8]
b. 25 Jul 1869 d. 22 Sep 1949 [
=>
]
12
George Alfred Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.6.9]
b. 27 Apr 1871 d. 27 Apr 1943 [
=>
]
12
Sarah Ellen Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.6.10]
b. 9 Feb 1873 d. 13 Jun 1961 [
=>
]
12
Esther Pricilla Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.6.11]
b. 20 Sep 1874 d. 1 Apr 1966
12
Mary Alice Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.6.12]
b. 4 Nov 1876 d. 17 Jun 1972 [
=>
]
12
Lucy Belle Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.6.13]
b. 4 Jul 1878 d. 6 Feb 1968 [
=>
]
12
Minnie Margaret Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.6.14]
b. 15 Apr 1880 d. 29 Jul 1961 [
=>
]
12
Clara Marinda Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.6.15]
b. 3 Feb 1883 d. 27 Sep 1966
12
Edith Ann Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.6.16]
b. 3 Jan 1885 d. 9 Jul 1947 [
=>
]
12
Albert Eli Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.6.17]
b. 20 Mar 1887 d. 11 Aug 1953 [
=>
]
12
Peter Preston Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.6.18]
b. 4 Oct 1888 d. 1 Dec 1967 [
=>
]
11
William M Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.7]
b. 4 Nov 1824
11
Martha Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.8]
b. 4 Jun 1825 d. 25 Dec 1867
William James Calkins
b. 17 Oct 1822 d. 10 Jun 1892
12
Eliza Ann Calkins
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.8.1]
b. 28 Jan 1854 d. 26 May 1930 [
=>
]
12
Martha Emeline Calkins
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.8.2]
b. Abt 1858 d. 1860
12
William Cyril Calkins, Jr
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.8.3]
b. 10 Aug 1864 d. 10 Jul 1929 [
=>
]
12
Alfred Arden Calkins
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.8.4]
b. 23 Dec 1867 d. 26 Dec 1867
11
George Alfred Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.9]
b. 4 May 1828 d. 18 Apr 1906
Lucy Ann Susan Saxey
b. 13 Jan 1842 d. 15 Jan 1892
12
Hannah Louisa Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.9.1]
b. 8 May 1860 d. 27 Aug 1921 [
=>
]
12
John Alfred Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.9.2]
b. 1 Jul 1864 d. 24 Jul 1948 [
=>
]
12
Mary Ellen Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.9.3]
b. 23 Sep 1866 d. 3 Feb 1928 [
=>
]
12
Elizabeth Lucy Ann Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.9.4]
b. 24 Aug 1861 d. 2 Nov 1893 [
=>
]
12
Willey Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.9.5]
b. 1869
12
George W Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.9.6]
b. 10 Dec 1869 d. 4 Jan 1936
12
Rosalle Elvira Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.9.7]
b. 15 Oct 1852 d. 20 Jul 1939 [
=>
]
12
William Daniel Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.9.8]
b. 10 Dec 1884 d. 18 Aug 1958 [
=>
]
12
Albert Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.9.9]
b. May 1885 d. 7 Jul 1923
11
John Bell Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.10]
b. 16 May 1830 d. 2 Feb 1902
Mary Senior
b. 2 Mar 1839 d. 20 May 1891
12
Mary Catherine Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.10.1]
b. 24 Oct 1863 d. 1864
12
John William Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.10.2]
b. 1864 d. 1864
12
Austin Robert Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.10.3]
b. 14 Jan 1866 d. 22 Sep 1942 [
=>
]
12
Ellen Elizabeth Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.10.4]
b. 1867 d. 1867
12
William Hyrum Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.10.5]
b. 27 Oct 1869 d. 24 Apr 1947 [
=>
]
12
George Edward Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.10.6]
b. 19 Mar 1871 d. 3 Jan 1874
12
John Bell Bennett, Jr
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.10.7]
b. 11 Oct 1872 d. 28 Feb 1946 [
=>
]
12
David Alfred Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.10.8]
b. 8 Aug 1874 d. 11 Oct 1945 [
=>
]
12
Sidney Redfern Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.10.9]
b. 18 Nov 1876 d. 27 Sep 1877
12
Samuel Senior Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.10.10]
b. 18 Nov 1876 d. 20 Jan 1951 [
=>
]
12
Joseph McGuire Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.10.11]
b. 13 Sep 1878 d. 4 Jan 1944 [
=>
]
12
Franklin Tennyson Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.10.12]
b. 21 Aug 1881 d. 25 Oct 1957 [
=>
]
11
Nancy Ellen Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.11]
b. 4 Jul 1833 d. 20 Mar 1909
Jesse Temple McCauslin
b. 24 Feb 1817 d. 6 Mar 1884
12
Mary Jane McCauslin
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.11.1]
b. 16 Apr 1854 d. 14 Jul 1939 [
=>
]
12
Sarah Ann McCauslin
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.11.2]
b. 29 Aug 1855 d. 30 Jan 1932 [
=>
]
12
Lydia Ellen McCauslin
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.11.3]
b. 1 May 1856 d. 3 Sep 1858
12
Caroline McCauslin
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.11.4]
b. 14 Nov 1858 d. 23 Sep 1930 [
=>
]
12
Jesse B McCauslin
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.11.5]
b. 13 Sep 1860 d. 16 Dec 1909 [
=>
]
12
George A McCauslin
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.11.6]
b. 6 Dec 1862 d. 12 Apr 1865
12
Alonzo McCauslin
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.11.7]
b. 1 May 1865 d. 22 May 1865
12
Elizabeth Mahala McCauslin
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.7.11.8]
b. 6 Jan 1867 d. 27 Jul 1933 [
=>
]
10
Clarissa Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.8]
b. Abt 1795 d. 1850
10
Catherine Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.9]
b. Abt 1796 d. Aft 1826
10
Nancy Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.2.10]
b. Abt 1797 d. Aft 1826
9
John Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.3]
b. Abt 1757 d. 6 Nov 1855
Mary Terry
b. 26 Jan 1775
10
William Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.3.1]
b. Abt 1797
10
Elizabeth Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.3.2]
b. Abt 1800
10
John R Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.3.3]
b. Abt 1803
10
Ann Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.3.4]
b. Abt 1809
+
Garner
b. Abt 1809
10
Sarah or Sally Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.1.3.5]
b. Abt 1812
8
Richard Bennett, Jr
[1.9.2.1.2.1.4.2]
b. Abt 1732
8
John Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.3]
b. Abt 1734 d. 18 Jul 1791
8
William Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.4]
b. Abt 1736
8
James Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.5]
b. Abt 1740
8
Fisher Rice Bennett
[1.9.2.1.2.1.4.6]
b. Abt 1743
6
Justephencia Bennett
[1.9.2.1.2.2]
b. Abt 1684
6
Sawyer Bennett
[1.9.2.1.2.3]
b. Abt 1686
6
Alexander Bennett
[1.9.2.1.2.4]
b. Abt 1688
5
Ann Bennett
[1.9.2.1.3]
b. Abt 1661
+
Richard E Perrin
b. 1637 d. 1 Apr 1695
5
Richard Bennett
[1.9.2.1.4]
b. Abt 1662
5
Mary Bennett
[1.9.2.1.5]
b. Abt 1665 d. Abt 1721
William Johnson
b. 29 Sep 1662 bur. Feb 1706
6
Susannah Johnson
[1.9.2.1.5.1]
b. 28 Jun 1688 d. 3 Jan 1735
6
Elizebeth Johnson
[1.9.2.1.5.2]
b. 1690 d. 11 Jan 1742
6
John Johnson
[1.9.2.1.5.3]
b. 1702 d. 1721
Joseph Ball
b. 24 May 1649 d. 25 Jun 1711
6
Mary Ball
[1.9.2.1.5.4]
b. 30 Nov 1708 d. 25 Aug 1789
Augustine Washington
b. 12 Nov 1694 d. 12 Apr 1743
7
President George Washington
[1.9.2.1.5.4.1]
b. 22 Feb 1732 d. 14 Dec 1799
+
Martha Dandridge
b. 2 Jun 1731 d. 22 May 1802
7
Betty Washington
[1.9.2.1.5.4.2]
b. 20 Jun 1733 d. 31 Mar 1797
7
Samuel Walter Washington
[1.9.2.1.5.4.3]
b. 16 Nov 1734 d. 26 Sep 1781
7
John Augustine Washington
[1.9.2.1.5.4.4]
b. 13 Jan 1737 d. 17 Feb 1787
7
Charles Washington
[1.9.2.1.5.4.5]
b. 2 May 1738 d. 16 Sep 1799
7
Mildred Washington
[1.9.2.1.5.4.6]
b. 21 Jun 1739 d. 23 Oct 1740
+
Captain Richard Hewes
b. Abt 1649 d. 1713
4
Richard Bennett
[1.9.2.2]
b. 21 Jan 1626 d. 21 Jan 1626
4
Philip Bennett
[1.9.2.3]
b. 6 Mar 1627
4
Alice Bennett
[1.9.2.4]
b. Abt 1629
3
Elizabeth Jane Bennett
[1.9.3]
b. 1602 d. 10 Mar 1681
Stephen Iggulden
b. 17 Jul 1608 d. 1634
4
John Eggleston
[1.9.3.1]
b. 1629 d. 1660
4
Sarah Eggleston
[1.9.3.2]
b. 1630 d. 10 Mar 1687
John Rawlings Nutting
b. 20 Aug 1620 d. 13 Mar 1676
5
John Rawlings Nutting, Jr
[1.9.3.2.1]
b. 25 Aug 1651 d. 2 Dec 1731
Mary Lakin
b. 16 Feb 1652 d. 3 Jan 1707
6
John Nutting
[1.9.3.2.1.1]
b. 1678 d. 1778
6
Richard Nutting
[1.9.3.2.1.2]
b. Abt 1684 d. Dec 1737
6
Ebenezer Nutting
[1.9.3.2.1.3]
b. 20 Nov 1686 d. 22 Jan 1762
6
Jonathan Nutting
[1.9.3.2.1.4]
b. 7 Jul 1689 d. Bef 19 May 1740
Mary Green
b. 3 Nov 1690 d. 24 Sep 1778
7
William Nutting
[1.9.3.2.1.4.1]
b. 20 Nov 1712 d. 2 Jun 1776
7
Sarah Nutting
[1.9.3.2.1.4.2]
b. 22 Feb 1714 d. 20 Jan 1799
7
Mary Nutting
[1.9.3.2.1.4.3]
b. 19 Nov 1718 d. Abt 1782
7
Jemina Nutting
[1.9.3.2.1.4.4]
b. 19 Sep 1720 d. 24 Nov 1810
7
Lydia Nutting
[1.9.3.2.1.4.5]
b. 20 Nov 1723 d. Nov 1812
7
Deborah Nutting
[1.9.3.2.1.4.6]
b. 30 Sep 1728 d. 2 Nov 1774
James Stone
b. 11 Aug 1727 d. 24 Jun 1788
8
James Stone
[1.9.3.2.1.4.6.1]
b. 31 May 1749 d. 21 May 1789
8
Jonathan Stone
[1.9.3.2.1.4.6.2]
b. 24 Oct 1750 d. 12 Aug 1795
8
Lemuel Stone
[1.9.3.2.1.4.6.3]
b. 23 Aug 1753 d. 1 Jun 1840
8
Mary Stone
[1.9.3.2.1.4.6.4]
b. 27 Sep 1755
8
Deborah Stone
[1.9.3.2.1.4.6.5]
b. 16 Aug 1757 d. 1791
8
William Stone
[1.9.3.2.1.4.6.6]
b. 20 Apr 1759 d. 18 Jul 1779
8
Eunice Stone
[1.9.3.2.1.4.6.7]
b. 10 Jan 1760
8
David Stone
[1.9.3.2.1.4.6.8]
b. 20 Oct 1761
8
Annis Stone
[1.9.3.2.1.4.6.9]
b. 22 Mar 1763
8
Lucy Stone
[1.9.3.2.1.4.6.10]
b. 16 Oct 1765 d. 22 Jun 1801
8
Hannah Stone
[1.9.3.2.1.4.6.11]
b. 28 Sep 1767 d. 4 Jul 1847
8
Phineas Stone
[1.9.3.2.1.4.6.12]
b. 22 Apr 1769
8
Josiah Stone
[1.9.3.2.1.4.6.13]
b. 1 Apr 1771
Sarah Daby
b. 7 Feb 1772
9
Josiah Stone
[1.9.3.2.1.4.6.13.1]
b. 29 Dec 1797
9
Levi Stone
[1.9.3.2.1.4.6.13.2]
b. 5 Sep 1799
9
Ezra Stone
[1.9.3.2.1.4.6.13.3]
b. 8 Dec 1801
9
Sarah Stone
[1.9.3.2.1.4.6.13.4]
b. 21 Apr 1805 d. 1849
Lucius Augustus Bingham
b. 1 Sep 1804
10
Calvin Bingham
[1.9.3.2.1.4.6.13.4.1]
b. 7 Sep 1827 d. 27 May 1883
10
Benjamin Bingham
[1.9.3.2.1.4.6.13.4.2]
b. 1829 d. 27 May 1883
10
Augustus Bingham
[1.9.3.2.1.4.6.13.4.3]
b. 27 Oct 1831 d. 20 May 1908
10
Levi Perry Bingham
[1.9.3.2.1.4.6.13.4.4]
b. 5 Nov 1832 d. 9 Oct 1903
Sarah Ann Elizabeth Lusk
b. 21 Nov 1833 d. 28 Apr 1893
11
Louisa Elizabeth Bingham
[1.9.3.2.1.4.6.13.4.4.1]
b. 22 Jun 1853 d. 7 Feb 1935
11
Susan Emaline Bingham
[1.9.3.2.1.4.6.13.4.4.2]
b. 16 Jun 1855 d. 26 Mar 1935
11
Perry Calvin Bingham
[1.9.3.2.1.4.6.13.4.4.3]
b. 29 Jun 1857 d. 17 Jul 1916
Rachel Elvira Henderson
b. 25 Jan 1858 d. 10 Dec 1907
12
Sarah Elvira Bingham
[1.9.3.2.1.4.6.13.4.4.3.1]
b. 10 Dec 1876 d. 11 Jan 1880
12
Louisa Emaline Bingham
[1.9.3.2.1.4.6.13.4.4.3.2]
b. 1 Jan 1879 d. 27 Jul 1959 [
=>
]
12
Perry Calvin Bingham
[1.9.3.2.1.4.6.13.4.4.3.3]
b. 4 Jan 1882 d. 10 Dec 1894
12
Effie Lucretia Bingham
[1.9.3.2.1.4.6.13.4.4.3.4]
b. 28 Dec 1884 d. 21 Oct 1946
12
Mary F Bingham
[1.9.3.2.1.4.6.13.4.4.3.5]
b. 29 Dec 1887 bur. Feb 1888
12
Dora Bingham
[1.9.3.2.1.4.6.13.4.4.3.6]
b. 29 Nov 1890
12
Zeida Bingham
[1.9.3.2.1.4.6.13.4.4.3.7]
b. 1 Jun 1895
11
John Samuel Bingham
[1.9.3.2.1.4.6.13.4.4.4]
b. 23 Feb 1860 d. 6 Sep 1927
11
Lucius Augustus Bingham
[1.9.3.2.1.4.6.13.4.4.5]
b. 5 Apr 1862 d. 16 Jan 1931
11
Lucy Lucretia Bingham
[1.9.3.2.1.4.6.13.4.4.6]
b. 28 Jun 1864 d. 2 Jul 1917
11
Sarah Maria Bingham
[1.9.3.2.1.4.6.13.4.4.7]
b. 8 Apr 1867 d. 16 Apr 1936
11
William David Bingham
[1.9.3.2.1.4.6.13.4.4.8]
b. 8 Jun 1870 d. 6 Sep 1899
11
Mary Ardella Bingham
[1.9.3.2.1.4.6.13.4.4.9]
b. 21 Sep 1874 d. 7 Dec 1915
10
Son Bingham
[1.9.3.2.1.4.6.13.4.5]
b. 10 May 1834 d. Abt 1835
10
Mary Emiline Bingham
[1.9.3.2.1.4.6.13.4.6]
b. 10 May 1834 d. 1874
10
Prosper Bingham
[1.9.3.2.1.4.6.13.4.7]
b. 1840 d. Abt 1845
10
Lucy Bingham
[1.9.3.2.1.4.6.13.4.8]
b. 1843
7
Ann Nutting
[1.9.3.2.1.4.7]
b. 22 May 1730 d. 24 Sep 1778
6
Daniel Nutting
[1.9.3.2.1.5]
b. Abt 1691 d. Abt 7 Aug 1756
6
Eleazer Nutting
[1.9.3.2.1.6]
b. Abt 1698 d. 10 Mar 1791
5
James Nutting
[1.9.3.2.2]
b. 28 Jun 1653 d. 15 May 1732
5
Mary Nutting
[1.9.3.2.3]
b. 10 Jan 1655 d. 1 Sep 1727
5
Josiah Nutting
[1.9.3.2.4]
b. 10 Jun 1657 d. 10 Dec 1658
5
Sarah Nutting
[1.9.3.2.5]
b. 7 Jan 1659 d. 1659
4
Ruth Eggleston
[1.9.3.3]
b. 1631 d. 14 Oct 1703
4
Elizabeth Eggleston
[1.9.3.4]
b. 9 Oct 1636 d. 20 Oct 1646
3
William Bennett
[1.9.4]
c. 21 Mar 1606
+
Dorothy Scott
b. 1611 d. 1680
3
Governor Richard Bennett
[1.9.5]
c. 6 Aug 1609 d. 12 Apr 1675
Mary Ann Longsworth
b. 1619 d. 1687
4
Elizabeth Bennett
[1.9.5.1]
b. 1642 d. 4 Aug 1719
Charles Scarborough
b. 1643 d. 6 Oct 1702
5
Bennett Scarborough
[1.9.5.1.1]
b. Abt 1673 bur. Abt 7 May 1734
5
Charles Scarborough
[1.9.5.1.2]
b. 1677 d. 5 Jan 1724/1725
5
Henry Scarborough
[1.9.5.1.3]
b. Abt 1679 bur. 4 Nov 1735
5
Tabitha Scarborough
[1.9.5.1.4]
b. 1680 bur. 1 Nov 1748
5
Mary Scarborough
[1.9.5.1.5]
b. Abt 1681 d. Aft 1721
5
Sarah Scarborough
[1.9.5.1.6]
b. 1683 d. 1728
4
Richard Bennett
[1.9.5.2]
b. 1643 d. 6 May 1667
4
Anna Bennett
[1.9.5.3]
d. Nov 1687
3
Philip Bennett
[1.9.6]
c. 22 May 1611
3
Johane Bennett
[1.9.7]
c. 7 Jul 1614 bur. 21 Aug 1616
2
Robert Bennett
[1.10]
c. 27 Apr 1571 d. 20 Nov 1623
Elizabeth Couch
b. Abt 1554
3
Elizabeth Bennet
[1.10.1]
b. Abt 1577
3
Richard Bennet
[1.10.2]
b. Abt 1577 d. 17 Apr 1617
3
William Bennet
[1.10.3]
b. Abt 1581
2
William Bennett
[1.11]
c. 15 Jun 1572 d. 16 Jul 1642
Alice Storey
b. Abt 1575 d. 1642
3
Johanne Bennett
[1.11.1]
c. 25 Apr 1604 bur. 2 Feb 1623
3
John Bennett
[1.11.2]
b. 17 Oct 1605 d. 1663
3
Agnes Bennett
[1.11.3]
c. 3 Nov 1606
3
Mary Bennett
[1.11.4]
c. 25 Jun 1609
3
Robert Bennett
[1.11.5]
c. 29 Dec 1611
3
Dorothy Bennett
[1.11.6]
c. 15 Apr 1615
3
Edward Bennett
[1.11.7]
b. 27 Jan 1617 d. Abt 1706
3
William Bennett
[1.11.8]
b. Abt 1620
3
Cordelia Bennett
[1.11.9]
b. Abt 1622
2
Richard Bennett
[1.12]
c. 9 Oct 1573 d. 28 Aug 1626
Judith Harris
b. Abt 1573 bur. 6 Aug 1686
3
Elizabeth Bennett
[1.12.1]
b. 1610 d. 1615
3
Abigail Bennett
[1.12.2]
b. 15 Nov 1612 bur. 13 Oct 1615
3
Ann Bennett
[1.12.3]
b. 20 Apr 1613 d. 1613
3
Ann Bennett
[1.12.4]
b. Apr 1615
3
Richard Bennet
[1.12.5]
b. 1616 d. 24 Sep 1618
3
Edward Bennett
[1.12.6]
b. 1618 d. 1619
2
Johan Bennett
[1.13]
c. 8 Jan 1575 d. 12 Jan 1575
2
Christopher Bennett
[1.14]
c. 6 May 1576 d. 1623
2
Edward Bennett
[1.15]
c. 2 Feb 1577 d. 3 Jun 1651
+
Mary Bourne
b. 1580 d. Aft 1635