Home Page
|
What's New
|
Photos
|
Histories
|
Headstones
|
Reports
|
Surnames
Search
First Name:
Last Name:
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Suomalainen
Svenska
Alice Anstie Tompson
1579 - 1647 (68 years)
Submit Photo / Document
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Submit Photo / Doc
Worksheet
Family
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Alice Anstie Tompson
[1]
b. 1579 d. 1647
Thomas Bennett
c. 2 Apr 1570 d. 26 Sep 1616
2
Robert Bennett
[1.1]
c. 1 Feb 1602 d. 1648
2
Thomas Bennett, Jr
[1.2]
c. 5 Nov 1603 d. 23 Dec 1668
Agnes Beard
b. 23 Dec 1608
3
John Bennett
[1.2.1]
c. 10 Jul 1624 d. Aft 1670
Mary Berry
b. Abt 1628 d. 1667
4
Robert Bennett
[1.2.1.1]
b. Abt 1656 d. 18 Feb 1684
Mary Smith
b. 1660 d. 1686
5
Thomas Bennett
[1.2.1.1.1]
b. 20 Mar 1685 d. 3 Jan 1763
4
William Bennett
[1.2.1.2]
b. Abt 1659 d. 18 Feb 1684
Mary Smith
b. 1663 d. 1686
5
William Bennett
[1.2.1.2.1]
b. Abt 1684 d. 1710
Sarah Brumwell
c. 2 Nov 1679 d. 1720
6
William Peter Bennett
[1.2.1.2.1.1]
b. 2 Jun 1703 d. Aft 24 Jul 1777
Mary Humphries
b. 24 Jan 1703 d. 6 Feb 1733
7
Peter Bennett
[1.2.1.2.1.1.1]
b. 21 Jun 1724 d. Jan 1778
7
Eliza Bennet
[1.2.1.2.1.1.2]
b. 1 Dec 1724
7
Elizabeth Bennett
[1.2.1.2.1.1.3]
b. 1 Dec 1726
7
William Bennett
[1.2.1.2.1.1.4]
b. 16 Dec 1727 d. Abt 1800
7
Joseph Bennett
[1.2.1.2.1.1.5]
b. 2 May 1731 d. 23 Apr 1837
Zipporah Whipple
b. 17 Mar 1757 d. 12 Mar 1810
8
Ralph Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.1]
b. 1778
8
Alfred Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.2]
b. 1780 d. 10 Mar 1861
8
Varney Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.3]
b. 1782
8
Zeporah Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.4]
b. 1783
8
Joseph Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5]
b. 11 Sep 1788
Lucina Bonny
b. 28 Aug 1792
9
Louisa Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.1]
b. 8 Jun 1813 d. 31 Oct 1879
Abner Augustus Ames
b. 23 Nov 1799 d. 26 Sep 1850
10
Ralph Franklin Ames
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.1]
b. 28 Aug 1835 d. 19 Jan 1919
Tirzah A Chappel
b. 22 Aug 1824 d. 7 Jan 1863
11
John Chappel Ames
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.1.1]
b. 27 Dec 1857
11
Anna Louisa Ames
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.1.2]
b. 23 Jul 1859 d. 1918
Joseph W Stubbs
b. Apr 1857 d. 14 Jan 1909
12
Mamie Belle Stubbs
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.1.2.1]
b. 18 Jul 1883 d. 11 Jan 1948 [
=>
]
12
Cora Edith Stubbs
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.1.2.2]
b. 5 Oct 1891 [
=>
]
Eunice Marie Biglow
b. 1 Jan 1846 d. 31 Oct 1937
11
Mary Samantha Ames
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.1.3]
b. 14 Dec 1864 d. 23 Oct 1928
Henry P Billings
b. Dec 1856 d. 1924
12
Guy A Billings
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.1.3.1]
b. 8 Jul 1884 d. 24 Nov 1884
12
Hazel Esther Billings
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.1.3.2]
b. 20 Jun 1889
12
Jessie A Billings
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.1.3.3]
b. 9 Sep 1891 d. 25 Feb 1903
11
William H Ames
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.1.4]
b. 29 Sep 1865 d. 2 Feb 1894
Louisa "Lydia" Colburn
b. 10 Jan 1875 d. 21 Sep 1933
12
Jessie Violet Ames
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.1.4.1]
b. 12 Oct 1893 d. 19 Apr 1982
11
Maria Ames
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.1.5]
b. 5 Feb 1869 d. 1942
11
Catherine Marie Ames
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.1.6]
b. 5 Feb 1869 d. 1938
Ovila Louis Fleury
b. 1869 d. 1928
12
Marguerite Dolores Fleury
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.1.6.1]
b. 30 Apr 1893 d. 11 Aug 1930
12
Rupert Lyle Fleury
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.1.6.2]
b. 30 Apr 1895 d. 19 Mar 1956
12
Eunice Marie Fleury
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.1.6.3]
b. 17 Jul 1897 d. 1 Apr 1971 [
=>
]
12
Ovila William Fleury
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.1.6.4]
b. 5 Jul 1901 d. 22 Jan 1958 [
=>
]
11
Margaret Mae Ames
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.1.7]
b. 6 May 1872 d. 5 Aug 1913
Robert Enoch Rowley
b. 23 Oct 1864 d. 10 Dec 1933
12
Glen Earl Rowley
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.1.7.1]
b. 13 Mar 1891 d. 26 Oct 1954
12
Roberta Rowley
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.1.7.2]
b. 29 Aug 1893 d. 24 Sep 1894
12
Maedra Rowley
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.1.7.3]
b. 1 Oct 1895 d. 20 Nov 1970 [
=>
]
12
Robert John Rowley
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.1.7.4]
b. 30 Jun 1905 d. Abt 1960
12
Son Rowley
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.1.7.5]
b. 30 Jun 1905 d. 30 Jun 1905
11
Ralph Franklin Ames, Jr
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.1.8]
b. 23 Jun 1876 d. 1952
Jessie Hathaway Barker
b. 24 Jul 1881 d. 12 Nov 1950
12
Richard Francis Ames
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.1.8.1]
b. 2 Nov 1911 d. 21 Jul 1937
11
Harry Ames
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.1.9]
b. 27 Feb 1880
11
Cora Ames
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.1.10]
b. 27 Feb 1880 d. 28 Mar 1888
11
Rex Gordon Ames
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.1.11]
b. 15 Jun 1884 d. May 1968
+
Margaret Wessel
b. Mar 1896 d. Apr 1985
11
Jessie V Ames
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.1.12]
b. 6 Sep 1886 d. 20 Oct 1886
11
Lowell Harmon Ames
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.1.13]
b. 26 Jan 1890 d. 21 Sep 1961
+
Olive Muriel Randall
b. 21 Nov 1890 d. 21 Nov 1963
10
Mary Elizabeth Ames
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.2]
b. 21 Dec 1839 d. 21 Jan 1911
James Osborne
b. 24 Apr 1830 d. 21 Dec 1900
11
William A Osborne
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.2.1]
b. 15 Aug 1858
11
Charles H Osborne
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.2.2]
b. Mar 1860 d. 1933
+
Sarah Hubler Canan
b. 27 Apr 1859 d. 1895
11
Olive Aurora Osborne
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.2.3]
b. 12 Apr 1862 d. 26 Oct 1944
William Nelson Thorn
b. 14 Jul 1853 d. 7 Aug 1911
12
Clarence Roscoe Thorn
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.2.3.1]
b. 6 Jul 1885 d. 2 Feb 1955 [
=>
]
12
Lewis Austin Thorn
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.2.3.2]
b. 11 Jul 1886 d. 8 Jan 1945
12
Cora A Thorn
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.2.3.3]
b. 11 Jun 1888 d. Sep 1969
12
Thomas Dewitt Thorn
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.2.3.4]
b. 25 Apr 1890 d. Oct 1975
12
William Harold Thorne
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.2.3.5]
b. 26 Nov 1891 d. Apr 1963
12
Fannie Elvira Thorn
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.2.3.6]
b. 11 Mar 1895 [
=>
]
12
Olive Esther Thorne
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.2.3.7]
b. 9 Apr 1897 d. Feb 1987
12
Charles Kenneth Thorne
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.2.3.8]
b. 20 Apr 1900 d. 14 Oct 1957
11
Joseph V Osborne
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.2.4]
b. 20 Mar 1864 d. 1938
10
Janette Clarissa Ames
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.3]
b. 19 Aug 1841 d. Sep 1903
Alexander Osburn
b. 1827 d. 4 May 1881
11
Adella May Osburn
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.3.1]
b. Apr 1864 d. 29 Jan 1923
Truman Loop
b. 2 Jun 1857 d. 7 Jan 1942
12
Ray Willis Loop
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.3.1.1]
b. 7 Aug 1882
12
Frank Layfotte Loop
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.3.1.2]
b. 7 Nov 1884
12
John Clayton Loop
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.3.1.3]
b. May 1887 d. 20 Sep 1940
12
Cecil Truman Loop
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.3.1.4]
b. 27 May 1891 d. 4 Mar 1963
12
Nellie L Loop
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.3.1.5]
b. Oct 1893
12
Mark Osburn Loop
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.3.1.6]
b. 15 Jun 1895 d. 27 May 1961
12
Frank L Loop
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.3.1.7]
b. Jun 1896 d. 29 Jan 1952
12
Madge Edith Loop
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.3.1.8]
b. 1901 d. 2 Mar 1923
12
Maude E Loop
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.3.1.9]
b. 1902
12
Rex William Loop
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.3.1.10]
b. 28 Jul 1905 d. 21 Apr 1949
12
William Loop
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.3.1.11]
b. 21 Aug 1911 d. 26 Oct 1983
11
William Welcome Osburn
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.3.2]
b. 1866 d. 3 Sep 1919
Vivie C Passenger
b. 1882
12
Hazel F Osburn
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.3.2.1]
b. Sep 1897
12
Ila M Osburn
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.3.2.2]
b. 1900
12
Florence Osburn
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.3.2.3]
b. 1902
12
Emmett E Osburn
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.3.2.4]
b. 26 Mar 1904 d. 18 Feb 1965 [
=>
]
12
Eunice Osburn
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.3.2.5]
b. 1905
12
Racheal Osburn
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.3.2.6]
b. 1906
12
Lloyd W Osburn
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.3.2.7]
b. 1910 d. 1976
12
Alexander Osburn
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.3.2.8]
b. 1912
11
John W Osburn
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.3.3]
b. 10 May 1882 d. 12 Feb 1945
Alma Martha Kuntz
b. 8 Jul 1886 d. 28 Jun 1964
12
Maud M Osburn
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.3.3.1]
b. 1896
12
John Osburn, Jr
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.3.3.2]
b. 1900
12
Pauline Osburn
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.3.3.3]
b. 25 Mar 1909 d. 1995 [
=>
]
10
Joseph Van Harmon Ames
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.4]
b. 22 Sep 1844 d. 1 May 1862
10
Olive Aurora Ames
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.5]
b. 22 Sep 1844 d. Apr 1849
10
Augustus Ames
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.6]
b. 1848 d. 1850
10
Jane Evaline Ames
[1.2.1.2.1.1.5.5.1.7]
b. 1849 d. 1850
9
Lucinda A Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.2]
b. 16 May 1816 d. 14 Jun 1903
Charles Putnum
b. 24 Mar 1810 d. 16 Mar 1892
10
Lubin Augustus Putnam
[1.2.1.2.1.1.5.5.2.1]
b. 1838
Mary Melissa Chase
b. 1849
11
Welie Lusina Putnam
[1.2.1.2.1.1.5.5.2.1.1]
b. 30 Dec 1870
+
Lucina Hand
b. 1840 d. 29 Jan 1882
10
Fernando Cortez Putnum
[1.2.1.2.1.1.5.5.2.2]
b. 28 Feb 1844 d. 29 Sep 1913
Abbie Bogue
b. 12 Sep 1859 d. 20 Jul 1931
11
Floyd Alger Putnam
[1.2.1.2.1.1.5.5.2.2.1]
b. 8 Jan 1887 d. Apr 1977
11
Ruth Lois Putnam
[1.2.1.2.1.1.5.5.2.2.2]
b. 13 Oct 1888 d. 12 May 1968
Paul V Hutchins
b. Mar 1883
12
Abbie Hutchins
[1.2.1.2.1.1.5.5.2.2.2.1]
b. 25 Sep 1912 d. 30 Apr 1922
Leon Merle Keeler
b. 7 Oct 1887 d. 30 Mar 1960
12
Fernando "Joe" Keeler
[1.2.1.2.1.1.5.5.2.2.2.2]
b. 23 Jul 1926 d. 1 Oct 1997 [
=>
]
12
Prudence Electa Keeler
[1.2.1.2.1.1.5.5.2.2.2.3]
b. 7 Nov 1927 d. 29 Aug 2007 [
=>
]
12
David Keeler
[1.2.1.2.1.1.5.5.2.2.2.4]
11
Helen O Putnam
[1.2.1.2.1.1.5.5.2.2.3]
b. 10 Aug 1890
11
Alma Putman
[1.2.1.2.1.1.5.5.2.2.4]
b. 6 Oct 1893
11
Olive Putnum
[1.2.1.2.1.1.5.5.2.2.5]
b. 6 Oct 1893 d. May 1984
+
Ray E Phillips
b. 15 May 1889 d. 14 Mar 1966
11
Marion E Putnum
[1.2.1.2.1.1.5.5.2.2.6]
b. 9 Jul 1899 d. Sep 1973
+
Cora Patten
b. 29 Oct 1882
11
Arthur Truman Putnam
[1.2.1.2.1.1.5.5.2.2.7]
b. 1906 d. 9 Oct 1906
10
Charles C Putnum
[1.2.1.2.1.1.5.5.2.3]
b. 13 May 1845 d. 2 Jan 1921
10
Elwood Putman
[1.2.1.2.1.1.5.5.2.4]
b. 1849
10
Daniel Putnum
[1.2.1.2.1.1.5.5.2.5]
9
George H Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.3]
b. 30 Mar 1818 d. 22 Oct 1886
Aurora Richardson
b. 1821 d. 17 Jun 1887
10
Son Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.3.1]
b. Abt 1846
10
Miranda Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.3.2]
b. Abt 1846 d. Abt 1865
10
Son Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.3.3]
b. 1848
9
Joseph Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.4]
b. 13 Jul 1819 d. 11 Apr 1883
+
Eliza
b. 1810 d. 20 Apr 1883
9
Varney E Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.5]
b. 10 Oct 1820 d. 6 Mar 1896
Jane Herrick
b. 15 Jun 1821 d. 24 Mar 1893
10
Dell Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.5.1]
b. 1848 d. 1918
Samantha Bennett
b. 1856 d. 1943
11
George Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.5.1.1]
b. 1877
11
Addie M Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.5.1.2]
b. 1879
William Silas Bair, Jr
b. 1865 d. 10 Apr 1952
12
William Delivan Bair
[1.2.1.2.1.1.5.5.5.1.2.1]
b. 29 Jan 1907 d. 20 May 1955
11
Dennis E Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.5.1.3]
b. 17 May 1887
+
Grace E Hoffman
b. 1880
10
Jackson Adelbert Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.5.2]
b. 24 Dec 1850 d. 12 Sep 1938
Josephine Augusta Cady
b. 7 Dec 1851 d. 28 Apr 1912
11
Harry Robinson Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.5.2.1]
b. 13 Sep 1872 d. 9 Sep 1944
Jennie Aletha Moore
b. 18 Feb 1877 d. 8 Feb 1968
12
Ila Fern Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.5.2.1.1]
b. 13 Aug 1894 d. 8 Nov 1972
12
Lila Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.5.2.1.2]
b. 6 Aug 1896 d. 9 Aug 1896
12
Fred Herbert Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.5.2.1.3]
b. 6 Oct 1897 d. 1 Mar 1986
12
Zelda Louise Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.5.2.1.4]
b. 6 Jan 1900 d. 27 Jul 1981
12
Mary Jane Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.5.2.1.5]
b. Abt 1901 d. 16 Aug 1987
12
James Albert Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.5.2.1.6]
b. 28 Sep 1903 d. 24 Feb 1919
12
Robert Jackson Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.5.2.1.7]
b. 29 Jan 1916 d. 23 Feb 1991
11
Otis Earl Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.5.2.2]
b. 18 Feb 1884 d. 13 Jan 1926
Alice Rose Crutchley
b. 4 Nov 1891 d. 19 Dec 1974
12
James Gordon Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.5.2.2.1]
b. 3 May 1913 d. 27 May 1995
12
Mildred Marie Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.5.2.2.2]
b. 28 Oct 1915 d. 11 Nov 2001
10
Elwood Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.5.3]
b. 3 Jan 1851 d. 30 Jun 1890
+
Mary Jane Milne
b. 1852 d. 23 May 1887
Onna Idzinga
b. 16 Mar 1869 d. 6 Feb 1920
11
Eva Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.5.3.1]
b. 7 Jun 1888 d. Dec 1970
+
Orvil Richardson
b. Mar 1879 d. 1957
11
Jessie Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.5.3.2]
b. 11 Oct 1889
10
Alfred Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.5.4]
b. 1857
+
Alice Fisher
b. 1876
10
Anna Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.5.5]
b. 1863
10
Gifford Allen Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.5.6]
b. 10 Jan 1863 d. 27 Jun 1916
Marcia C Nichols
b. 6 Feb 1856 d. 21 Jul 1936
11
Josephine Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.5.6.1]
b. Nov 1891
11
Harry E Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.5.6.2]
b. 4 Oct 1894 d. 6 Oct 1984
Carrie Elizabeth Lawton
b. 5 Apr 1899 d. 9 Sep 1969
12
Orlie Lewis Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.5.6.2.1]
b. 31 May 1930 d. 18 Dec 1996
12
Marian L "Marcia" Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.5.6.2.2]
b. 1938 d. 1963
+
Evelyn Marie Brown
b. 19 Apr 1902 d. 25 Aug 1987
10
Dennis H Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.5.7]
d. 9 Jan 1940
Emma Jenkins
11
Nellie Ann Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.5.7.1]
b. 1895
9
Sophia Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.6]
b. 17 Jun 1822
9
Josiah Hibbard Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.7]
b. 12 Jul 1824 d. 8 Mar 1904
9
Truman Sherman Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.8]
b. 28 Mar 1826 d. 26 Mar 1899
Huldah Edson
b. 26 Aug 1831 d. 6 Sep 1876
10
Horatio Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.1]
b. 26 May 1850 d. 1850
10
Ezra T Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.2]
b. 1 Jun 1851 d. 1851
10
Walter Ancil Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.3]
b. 11 May 1854 d. 27 Feb 1926
Emily Ida Bunker
b. 14 Jan 1852 d. 18 Sep 1913
11
Martha Elizabeth Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.3.1]
b. 27 Jul 1878
+
Marvin Clendenning
b. Abt 1875
11
Charles Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.3.2]
b. 1880
11
Perez Nathaniel Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.3.3]
b. 8 Apr 1883
+
Almira S Buttermore
b. 28 Dec 1884 d. 4 Oct 1929
+
Mary Jane Tullis
b. 1900
11
Winifred Isabelle Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.3.4]
b. 7 Jan 1889 d. 3 Apr 1974
+
Myron Clifton Dutton
b. 10 May 1884 d. 6 Feb 1962
+
Alice Elnora Altice
b. 1849
10
Evaline Viola Bennet
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.4]
b. 24 Jan 1859 d. 20 May 1943
Sylvaneus M Turner
b. 2 Aug 1852 d. 30 Jan 1924
11
Grace H Turner
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.4.1]
b. 11 Sep 1876 d. 17 Sep 1943
Erwin E Maxson
b. 5 Dec 1869 d. 5 May 1930
12
Winona B Maxson
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.4.1.1]
b. Mar 1895
12
Hazel E Maxson
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.4.1.2]
b. Aug 1896 d. 19 Mar 1956 [
=>
]
12
Eva G Maxson
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.4.1.3]
b. Jun 1898
12
Irma E Maxson
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.4.1.4]
b. 1901 d. 1954 [
=>
]
12
Elmer F Maxson
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.4.1.5]
b. 13 Jun 1904 d. 14 Apr 1926
12
Ernestine Ruby Maxson
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.4.1.6]
b. 24 Aug 1909 d. 24 Jan 1923
12
Ernstine I Maxson
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.4.1.7]
b. 1910
12
Ernest W Maxson
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.4.1.8]
b. 1913 d. 20 Oct 1991 [
=>
]
12
Welcome Rexford Maxson
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.4.1.9]
b. 30 Oct 1916 d. 27 May 1990
11
Lucy Eveline Turner
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.4.2]
b. 1879 d. 1974
Harley B McDowell
b. Abt 1878 d. 1959
12
Orlie McDowell
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.4.2.1]
b. Abt 1904 d. 1975
12
Zelda J McDowell
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.4.2.2]
b. 1905
12
Oda McDowell
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.4.2.3]
b. 1910
12
Hennrietta Evelyn McDowell
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.4.2.4]
b. 14 Aug 1912 d. 3 Nov 1975
11
Clara Gertrude Turner
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.4.3]
b. Abt 1879 d. 1885
11
Wellman Ellery Turner
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.4.4]
b. 20 Sep 1881 d. 7 Mar 1953
Clara Sutton
b. 19 Oct 1883 d. Abt 1948
12
Herbert H Turner
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.4.4.1]
b. 29 Jun 1901 d. 18 Mar 1988
12
Dudley Otis Turner
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.4.4.2]
b. 10 Sep 1905 d. 10 Jan 1984 [
=>
]
12
Mary C Turner
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.4.4.3]
b. 1 Jul 1907 d. 24 Apr 1994 [
=>
]
12
Living
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.4.4.4]
12
Living
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.4.4.5]
11
Truman Herbert Turner
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.4.5]
b. 14 Oct 1882 d. 1933
Flora Alberta Terrette
b. 16 Feb 1895 d. 1986
12
Carl V Turner
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.4.5.1]
b. 31 Aug 1915 d. 9 Feb 2001
12
Ruth Turner
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.4.5.2]
b. 5 May 1917 d. 29 Dec 2010
11
Ernest S Turner
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.4.6]
b. Aug 1884
11
Permilla A Turner
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.4.7]
b. Sep 1886
11
Rexford Archibald Turner
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.4.8]
b. 30 Oct 1887
Margaret Christine O'Toole
b. 27 Sep 1884 d. 1971
12
Margaret Turner
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.4.8.1]
b. 17 Mar 1908 d. 8 Nov 1995 [
=>
]
12
Lucy E Turner
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.4.8.2]
b. 21 Mar 1910 d. 6 Jun 1986 [
=>
]
12
Erwin P Turner
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.4.8.3]
b. 23 Sep 1912 d. 27 Dec 1997 [
=>
]
12
Lena Agnes Turner
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.4.8.4]
b. 1914 d. 1981 [
=>
]
12
Living
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.4.8.5]
12
Living
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.4.8.6]
10
Wellman George Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.5]
b. 28 May 1862 d. 21 Feb 1898
Addie Rose Willey
b. 26 Nov 1867 d. 23 Oct 1955
11
Mabel Evelyn Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.5.1]
b. 28 Oct 1889 d. 1953
Harry Orman Whittemore
b. 24 Oct 1889 d. 1952
12
Craig Lowell Whittemore
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.5.1.1]
b. 11 Nov 1910 d. 22 Aug 1948
12
Beryl Whittemore
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.5.1.2]
b. 12 Mar 1912 d. 5 May 1998
12
Myrtle Eileen Whittemore
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.5.1.3]
b. 1 Sep 1916 d. 25 Nov 2006
11
Gardner Byron Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.5.2]
b. 21 Dec 1889 d. 17 Sep 1956
Florence Edith Chambers
b. 10 Nov 1893 d. 15 May 1968
12
George Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.5.2.1]
b. 1914
12
Living
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.5.2.2]
12
Byron Gardner Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.5.2.3]
b. 27 May 1917 d. 21 Apr 2015
12
Living
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.5.2.4]
12
Living
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.5.2.5]
11
Clifton L Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.5.3]
b. 12 Oct 1891 d. Oct 1976
+
Bertha M Menter
b. Mar 1896
11
Ethel Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.5.4]
b. 3 Aug 1893 d. May 1928
+
Frank J Dobner
b. 4 Oct 1890 d. 21 Mar 1957
10
Dolly Arluine Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.6]
b. 25 Sep 1865 d. 1 Jan 1899
George B Olmstead
b. 2 Oct 1861 d. 16 Feb 1943
11
Willard Russell Olmstead
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.6.1]
b. 16 Sep 1884 d. 28 Mar 1920
Isabell Getchell
b. Mar 1887
12
Merle Olmstead
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.6.1.1]
b. 26 Jan 1906 d. 10 Apr 1906
12
Richard Charles Olmstead
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.6.1.2]
b. 15 Dec 1907 d. 18 Feb 1969
11
Francis Walter Olmstead
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.6.2]
b. 23 Dec 1885 d. 27 Aug 1963
Mary Arlouine Kimble
b. 25 Sep 1886 d. 21 Jan 1921
12
Arluine Mary Olmstead
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.6.2.1]
b. 14 Aug 1909 d. 14 Dec 1947
12
Irene E Olmstead
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.6.2.2]
b. 1912
12
Bruce Kimble Olmstead
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.6.2.3]
b. 22 Mar 1914 d. 28 Dec 1952
Julia Abigal Wirt
b. Nov 1890 d. 16 Jul 1942
12
Roy J Olmstead
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.6.2.4]
b. 29 Apr 1926 d. 23 Oct 2010
+
DeEtta Mae Clark
b. 25 May 1881 d. 6 Jan 1967
11
Nathanial R Olmstead
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.6.3]
b. 21 Nov 1888 d. 27 Jun 1946
Zella R Smith
b. 9 Nov 1893 d. 8 Jul 1987
12
Zelma Marion Olmstead
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.6.3.1]
b. 19 Jan 1912 d. 31 Mar 2002 [
=>
]
12
Eva Eloise Olmstead
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.6.3.2]
b. 22 Sep 1914 d. 1 Mar 1999
12
Living
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.6.3.3]
12
Llewllyn G Olmstead
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.6.3.4]
b. 28 Apr 1916 d. 3 Mar 2001
12
Richard E Olmstead
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.6.3.5]
b. 26 Nov 1918 d. 29 Mar 1998
12
Elwin Ray Olmstead
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.6.3.6]
b. 2 Jan 1920 d. Mar 1987
12
Cecil N Olmstead
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.6.3.7]
b. 24 May 1924 d. 30 Mar 2010
12
Albert W Olmstead
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.6.3.8]
b. 4 Aug 1931 d. 11 Apr 2014
11
Ralph Ellery Olmstead
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.6.4]
b. 30 Sep 1891 d. Nov 1979
Nina M Taylor
b. 26 Mar 1892 d. 9 Apr 1964
12
Oscar Olmstead
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.6.4.1]
b. 1913
12
Living
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.6.4.2]
11
Floyd Ezra Olmstead
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.6.5]
b. 13 Jun 1893 d. 15 May 1961
Flora Bell Harris
b. 21 Jun 1899 d. 23 May 1982
12
Esther Mary Olmstead
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.6.5.1]
b. 21 Sep 1916 d. 25 Aug 1988
12
Eleanor Maud Olmstead
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.6.5.2]
b. 3 Jun 1920 d. 25 Oct 1998
12
Roah Mae Olmstead
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.6.5.3]
b. 22 Jul 1925 d. 7 Feb 2006
12
Floyd Ezra Olmstead, Junior
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.6.5.4]
b. 8 Jan 1935 d. 10 Apr 2015 [
=>
]
11
Eda Arluine "Edith" Olmstead
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.6.6]
b. 9 May 1895 d. May 1985
+
Allan Oviatt Hyde
b. 9 Jun 1894 d. 21 Nov 1965
+
Floyd Roswell Taylor
b. 6 Aug 1889 d. 27 Apr 1927
10
Lowell E Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.8.7]
b. 1 Jun 1868
9
Hannah Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.5.9]
b. 15 Jun 1829
8
Thankful Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.6]
b. 1791
8
William Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7]
b. 1795 d. 23 Jun 1863
Lydia Caryl
b. 24 Jan 1797 d. 1868
9
William Bennett, Jr
[1.2.1.2.1.1.5.7.1]
b. Jan 1822 d. 1904
Hannah Jane Kibbe
b. 16 Sep 1832
10
Raymond A Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.1.1]
b. 12 Jan 1853 d. 6 Sep 1921
+
Anna Belle Noble
b. Apr 1866
10
Finley Anson Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.1.2]
b. Aug 1854
10
Elva Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.1.3]
b. 1857
Daniel Spencer
11
Tuphina Spencer
[1.2.1.2.1.1.5.7.1.3.1]
b. 23 Dec 1873
10
Ada Fidelia Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.1.4]
b. 1861
David William Smith
b. 26 Dec 1853 d. 23 Aug 1917
11
Willliam Henry Smith
[1.2.1.2.1.1.5.7.1.4.1]
b. 2 Feb 1880 d. May 1981
Caroline Julia Burri
b. 18 Dec 1877 d. 20 Apr 1964
12
Vernon Leroy Smith
[1.2.1.2.1.1.5.7.1.4.1.1]
b. 24 Mar 1903 d. 27 Feb 1991
12
Preston Raymond Smith
[1.2.1.2.1.1.5.7.1.4.1.2]
b. 1907 d. 11 Dec 1978
12
Olympia Gertrude Smith
[1.2.1.2.1.1.5.7.1.4.1.3]
b. 10 Oct 1909 d. 28 Dec 1994 [
=>
]
10
Emma Jane Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.1.5]
b. 10 Mar 1862 d. 25 Sep 1931
10
Henry E Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.1.6]
b. 1864 d. 1895
Hattie Helen Jackson
b. 1870
11
Henry M Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.1.6.1]
b. 6 Nov 1891
11
Eva Maude Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.1.6.2]
b. 21 Jun 1894
10
Louisa Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.1.7]
b. 16 May 1870 d. 1930
9
Alonzo Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.2]
b. 10 Nov 1824 d. 2 Oct 1884
+
Maryette Moore
b. Abt 1824
Margaret Maxwell
b. 25 Sep 1835 d. 27 May 1915
10
Willis Lugene Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.2.1]
b. 8 Mar 1858 d. 2 Jun 1924
Sarah Crosby "Sallie" Babbitt
b. Sep 1855 d. 29 Jul 1897
11
Winifred Elizabeth Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.2.1.1]
b. 16 Jan 1890 d. 7 May 1965
Ernest Hiram Smith
b. 24 Aug 1882 d. 26 Nov 1961
12
Wilbur Wilkes Smith
[1.2.1.2.1.1.5.7.2.1.1.1]
b. 21 Sep 1911 d. 25 Jan 1987
12
Gerald Eugene Smith
[1.2.1.2.1.1.5.7.2.1.1.2]
b. 6 Jul 1914 d. 9 Feb 1957
12
Edwin L Smith
[1.2.1.2.1.1.5.7.2.1.1.3]
b. 20 May 1916 d. 18 Nov 1990
12
Alfred Leroy Smith
[1.2.1.2.1.1.5.7.2.1.1.4]
b. 5 Jul 1919 d. 15 Feb 1987
11
George Russell Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.2.1.2]
b. 13 Feb 1893 d. 14 Sep 1893
+
Louiza Evelyn Smith
b. 10 Apr 1866 d. 6 Dec 1958
10
Nettie Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.2.2]
b. 1859
10
Alpha Alonzo Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.2.3]
b. 26 May 1860 d. 21 Dec 1931
Mary Belle Spencer
b. Oct 1868 d. 21 Jun 1932
11
Effie May Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.2.3.1]
b. 30 May 1887 d. 14 Jun 1894
11
Frederick Spencer Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.2.3.2]
b. 19 Jun 1893 d. 13 Jun 1972
Cecil Agatha Barker
b. 6 Mar 1900
12
Bette Louise Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.2.3.2.1]
b. 16 Apr 1921 d. 16 Mar 1964
12
Nina Arlene Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.2.3.2.2]
b. 16 Jan 1928 d. 16 Jan 1928
11
Forest Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.2.3.3]
b. 1897
11
David Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.2.3.4]
b. 1902
10
Effie May Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.2.4]
b. Abt May 1862 d. 10 Dec 1943
George Gilbert
b. 15 Feb 1858 d. 1939
11
Edith M Gilbert
[1.2.1.2.1.1.5.7.2.4.1]
b. 27 Jan 1884
Herman C Bodie
b. Abt 1882 d. 18 Jan 1912
12
Irene Bodie
[1.2.1.2.1.1.5.7.2.4.1.1]
b. 24 Apr 1905 d. 14 Jan 1995
12
Esther Bodie
[1.2.1.2.1.1.5.7.2.4.1.2]
b. 1908 d. 16 Apr 1973
12
Marjorie Bodie
[1.2.1.2.1.1.5.7.2.4.1.3]
b. 1911
11
Georgia Etta Gilbert
[1.2.1.2.1.1.5.7.2.4.2]
b. Apr 1886 d. 22 Mar 1910
Lee Wiseman Mains
b. 14 May 1887 d. 24 Feb 1939
12
Lee D Mains
[1.2.1.2.1.1.5.7.2.4.2.1]
b. 8 Jun 1906 d. 21 May 1974 [
=>
]
11
George Gilbert
[1.2.1.2.1.1.5.7.2.4.3]
b. Jan 1892 d. 26 Apr 1910
11
Emma Gilbert
[1.2.1.2.1.1.5.7.2.4.4]
b. 16 Jan 1900
11
Treva Marguerite Gilbert
[1.2.1.2.1.1.5.7.2.4.5]
b. 16 Jan 1900 d. 6 Feb 1992
Orville Ellis Kenyon
b. 4 Sep 1899 d. 6 Mar 1952
12
Living
[1.2.1.2.1.1.5.7.2.4.5.1]
12
Living
[1.2.1.2.1.1.5.7.2.4.5.2]
12
Living
[1.2.1.2.1.1.5.7.2.4.5.3]
10
Margaret Emma Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.2.5]
b. 12 Aug 1862 d. 11 Jan 1915
William Henry Abell
b. 18 Oct 1855 d. 1 Feb 1916
11
Bert W Abell
[1.2.1.2.1.1.5.7.2.5.1]
b. Oct 1877
11
Glenn Henry Abell
[1.2.1.2.1.1.5.7.2.5.2]
b. 22 May 1880 d. 29 Aug 1906
Dorothy Jane May Davies
b. 5 Jul 1875 d. 9 Apr 1945
12
Stanley Glenn Abell
[1.2.1.2.1.1.5.7.2.5.2.1]
b. 5 Apr 1903 d. 1 May 1961 [
=>
]
12
Margaret Arlene Dorothy Abell
[1.2.1.2.1.1.5.7.2.5.2.2]
b. 4 Jun 1906 d. 1 Feb 1973 [
=>
]
10
Albert D Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.2.6]
b. 1863 d. 19 May 1893
10
Dora Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.2.7]
b. 1866
10
Adelbert Glen Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.2.8]
b. 6 Sep 1869
Rose M Halstead
b. 26 Feb 1874 d. 14 Jul 1940
11
Lloyd Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.2.8.1]
b. 1894 d. 8 May 1896
11
Ovid Earl Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.2.8.2]
b. 10 Jun 1897 d. 18 Nov 1968
Lenna Maebell DeGraff
b. 1 Sep 1898
12
Alton Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.2.8.2.1]
b. 3 Sep 1919 d. 15 Sep 1990
12
Living
[1.2.1.2.1.1.5.7.2.8.2.2]
12
Living
[1.2.1.2.1.1.5.7.2.8.2.3]
10
Minnie Adora Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.2.9]
b. 21 May 1871 d. 26 Jul 1939
Merton Eugene Cobb
b. 20 Aug 1871 d. 28 Apr 1951
11
Minnie M Cobb
[1.2.1.2.1.1.5.7.2.9.1]
b. 25 Aug 1894 d. 25 Aug 1894
11
Lila Pauline Cobb
[1.2.1.2.1.1.5.7.2.9.2]
b. 23 Jul 1897 d. 17 Oct 1997
Harry Hardman Shafer
b. 15 Nov 1895 d. 22 Jul 1961
12
Leslie Lee Shafer
[1.2.1.2.1.1.5.7.2.9.2.1]
b. 16 Nov 1918 d. 26 Mar 1995
12
Phil Jordan Shafer
[1.2.1.2.1.1.5.7.2.9.2.2]
b. 25 May 1928 d. 31 Mar 2010
11
Lloyd McKinley Cobb
[1.2.1.2.1.1.5.7.2.9.3]
b. 28 Feb 1899 d. 31 May 1988
+
Marjorie VanDervort
b. 19 Jun 1903 d. 19 May 1993
11
Reva L Cobb
[1.2.1.2.1.1.5.7.2.9.4]
b. 13 Jul 1907 d. 1 Jun 1996
+
Kenneth G Stantial
b. 13 Jan 1906 d. 24 Mar 1994
+
Herman W Sprout
b. 1904 d. 6 Oct 1958
11
Rena M Cobb
[1.2.1.2.1.1.5.7.2.9.5]
b. 13 Jul 1907 d. 22 Jan 1995
+
Clarence Turner
b. 1907
9
Anna Orpha Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.3]
b. 3 Sep 1826 d. 29 Aug 1909
Obed Rust
b. 22 Aug 1824 d. 30 Jun 1869
10
Caroline Rust
[1.2.1.2.1.1.5.7.3.1]
b. 1848
10
Corodyne O Rust
[1.2.1.2.1.1.5.7.3.2]
b. 26 Apr 1848 d. 27 Jun 1898
Ann L Baker
b. 5 Jan 1850 d. 16 May 1922
11
Luther Rust
[1.2.1.2.1.1.5.7.3.2.1]
b. 13 Jul 1874
11
Bert Hart Rust
[1.2.1.2.1.1.5.7.3.2.2]
b. 8 Jan 1877 d. 6 Jul 1945
+
Alice June Emerson
b. 5 Jun 1878 d. 1967
11
Bertrand Rust
[1.2.1.2.1.1.5.7.3.2.3]
b. 12 Feb 1877
11
Gertrude E Rust
[1.2.1.2.1.1.5.7.3.2.4]
b. 21 Jan 1880 d. 3 Jun 1911
Bert E Stanhope
b. 1882 d. 20 May 1925
12
Wilda Eliza Stanhope
[1.2.1.2.1.1.5.7.3.2.4.1]
b. 12 Oct 1908 d. 27 Feb 1919
11
Platt William Rust
[1.2.1.2.1.1.5.7.3.2.5]
b. 19 Nov 1887 d. 1957
Laura E Benedict
b. 28 May 1884 d. Jan 1965
12
Natalie I Rust
[1.2.1.2.1.1.5.7.3.2.5.1]
b. 25 May 1912 d. 1 Oct 1996
10
Truman H Rust
[1.2.1.2.1.1.5.7.3.3]
b. 1850
+
Kate L Weed
b. 1855
10
Eva L Rust
[1.2.1.2.1.1.5.7.3.4]
b. 23 Dec 1852 d. 19 Aug 1911
+
Charles E Carroll
b. 1860
10
Ida A Rust
[1.2.1.2.1.1.5.7.3.5]
b. 27 Sep 1855 d. 6 Feb 1892
Andrew J Carroll
b. 15 Apr 1854 d. 3 Mar 1917
11
Henry Willard Carroll
[1.2.1.2.1.1.5.7.3.5.1]
b. 21 Jan 1878
11
Eva Maud Carroll
[1.2.1.2.1.1.5.7.3.5.2]
b. 17 Oct 1879 d. 12 Dec 1911
11
Anna G Carroll
[1.2.1.2.1.1.5.7.3.5.3]
b. 15 Mar 1888 d. 29 Jun 1909
10
Densie R Rust
[1.2.1.2.1.1.5.7.3.6]
b. 20 Aug 1857
+
John H French
b. 28 Sep 1850 d. 23 Dec 1932
10
Carrie O Rust
[1.2.1.2.1.1.5.7.3.7]
b. 20 Apr 1861 d. 9 Sep 1865
10
Harmon H Rust
[1.2.1.2.1.1.5.7.3.8]
b. 1 May 1863 d. 3 Sep 1865
10
Ada W Rust
[1.2.1.2.1.1.5.7.3.9]
b. 30 May 1865
10
Add W Rust
[1.2.1.2.1.1.5.7.3.10]
b. 30 May 1865 d. 25 Sep 1919
+
Bertha V Baker
b. 1861
+
Margaret H Smith
b. 1856
10
Elisha D Rust
[1.2.1.2.1.1.5.7.3.11]
b. 28 Oct 1868 d. 31 May 1929
Minnie E Brookins
b. Nov 1867
11
Olive Blanche Rust
[1.2.1.2.1.1.5.7.3.11.1]
b. Feb 1898 d. 31 Mar 1991
+
Percival Jacob Parker
b. 19 Jun 1896 d. 26 Dec 1958
11
Hubert M Rust
[1.2.1.2.1.1.5.7.3.11.2]
b. Abt 1902 d. Aft 1991
11
Donald E Rust
[1.2.1.2.1.1.5.7.3.11.3]
b. 13 Sep 1904 d. 19 Jul 1993
11
Hazel Rust
[1.2.1.2.1.1.5.7.3.11.4]
b. 1906 d. Aft 1991
11
Hazel Rust
[1.2.1.2.1.1.5.7.3.11.5]
b. 1907
11
Hudson Rust
[1.2.1.2.1.1.5.7.3.11.6]
b. 1912
9
Arvilla Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.4]
b. Oct 1828 d. 28 Mar 1907
David C Hollis
b. Nov 1824 d. 9 Jun 1892
10
Albert A Hollis
[1.2.1.2.1.1.5.7.4.1]
b. 6 Jun 1852 d. 11 Mar 1877
Jane Eliza Dudley
b. 5 Aug 1851 d. 6 Feb 1939
11
Harvey Albert Hollis
[1.2.1.2.1.1.5.7.4.1.1]
b. 26 Dec 1874 d. 12 Oct 1876
11
Clanie B Hollis
[1.2.1.2.1.1.5.7.4.1.2]
b. 24 Aug 1876
10
Flora M Hollis
[1.2.1.2.1.1.5.7.4.2]
b. 19 Jul 1853 d. 30 Apr 1879
+
George Daniel Andrews
b. 8 Aug 1850 d. 2 Feb 1919
10
Nettie E Hollis
[1.2.1.2.1.1.5.7.4.3]
b. Mar 1856 d. 21 Aug 1858
10
Willie W Hollis
[1.2.1.2.1.1.5.7.4.4]
b. Mar 1860 d. 6 Apr 1862
10
Nellie Arvilla Hollis
[1.2.1.2.1.1.5.7.4.5]
b. May 1863 d. 2 Dec 1941
Charles Emerson Walters
b. 12 Jun 1861 d. 24 Sep 1938
11
David Irwin Walters
[1.2.1.2.1.1.5.7.4.5.1]
b. 17 Aug 1883 d. 29 Nov 1964
+
Matie A Lent
b. Abt 1886
11
Arvilla Hannah Walters
[1.2.1.2.1.1.5.7.4.5.2]
b. 26 Jun 1886 d. 18 Mar 1970
Harley Franklin Goodrich
b. 10 Oct 1883 d. Dec 1962
12
Harvey W Goodrich
[1.2.1.2.1.1.5.7.4.5.2.1]
b. 9 Mar 1904
12
Thelma A Goodrich
[1.2.1.2.1.1.5.7.4.5.2.2]
b. 1910
9
Anson Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.5]
b. Nov 1830 d. 24 Apr 1905
Celia Eliza Durkee
b. 30 Apr 1838 d. 19 Mar 1926
10
John M Bennet
[1.2.1.2.1.1.5.7.5.1]
b. Jun 1861 d. 10 Jun 1917
10
Lola M Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.5.2]
b. 1862 d. 20 Jun 1934
+
James T Calder
b. Abt 1857
10
Ernest O Bennet
[1.2.1.2.1.1.5.7.5.3]
b. 11 Jul 1872 d. 15 May 1945
9
Maria Lydia Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.6]
b. 14 Nov 1832 d. 8 May 1916
Albert F Horton
b. 21 Jul 1828 d. 8 Dec 1914
10
Franklin S Horton
[1.2.1.2.1.1.5.7.6.1]
b. 21 May 1855 d. 27 Jul 1935
Nora B Dana
b. 28 Feb 1865 d. 25 Apr 1912
11
Alice M Horton
[1.2.1.2.1.1.5.7.6.1.1]
b. 20 Sep 1886
+
Roy S Smith
b. 1885
+
Myrtle Kitchen
b. Jul 1870
10
Herbert Henry Horton
[1.2.1.2.1.1.5.7.6.2]
b. Mar 1863 d. 10 May 1918
Lydia Lindner
b. 19 Jul 1863 d. 1 Feb 1904
11
Eva May Horton
[1.2.1.2.1.1.5.7.6.2.1]
b. 13 Jun 1884
11
Verna H Vanether
[1.2.1.2.1.1.5.7.6.2.2]
b. 1886
11
Herbert H Horton
[1.2.1.2.1.1.5.7.6.2.3]
b. May 1886 d. 1978
Lavina E Potter
b. 22 Aug 1888 d. 7 Oct 1973
12
Ruth M Horton
[1.2.1.2.1.1.5.7.6.2.3.1]
b. 1907 d. Bef 1980 [
=>
]
12
Ethlyn Horton
[1.2.1.2.1.1.5.7.6.2.3.2]
b. 1908
12
Living
[1.2.1.2.1.1.5.7.6.2.3.3]
12
Raymond Nelson Horton
[1.2.1.2.1.1.5.7.6.2.3.4]
b. 25 Mar 1920 d. 22 May 1999
12
Living
[1.2.1.2.1.1.5.7.6.2.3.5]
12
Living
[1.2.1.2.1.1.5.7.6.2.3.6]
11
Elizabeth Horton
[1.2.1.2.1.1.5.7.6.2.4]
b. 1 May 1888 d. 2 Aug 1921
Romine Louis Pollok
b. 4 Feb 1864 d. 14 May 1936
12
Lydia E Pollok
[1.2.1.2.1.1.5.7.6.2.4.1]
b. 1909
12
Zelma G Pollok
[1.2.1.2.1.1.5.7.6.2.4.2]
b. 8 Apr 1911 d. 11 Dec 1940
12
Lavina E Pollok
[1.2.1.2.1.1.5.7.6.2.4.3]
b. 1913
12
Living
[1.2.1.2.1.1.5.7.6.2.4.4]
11
Nellie Horton
[1.2.1.2.1.1.5.7.6.2.5]
b. 14 Jul 1890
Hugh Potter
b. 1891
12
Iva L Potter
[1.2.1.2.1.1.5.7.6.2.5.1]
b. 1912
12
Alma M Potter
[1.2.1.2.1.1.5.7.6.2.5.2]
b. 1914
12
Living
[1.2.1.2.1.1.5.7.6.2.5.3]
12
Living
[1.2.1.2.1.1.5.7.6.2.5.4]
11
Banker Horton
[1.2.1.2.1.1.5.7.6.2.6]
b. 16 Mar 1893
Ethel May Donley
b. 9 Jan 1897
12
Shirley Horton
[1.2.1.2.1.1.5.7.6.2.6.1]
b. 17 Mar 1928 d. 13 Jan 2011
11
Bryan Horton
[1.2.1.2.1.1.5.7.6.2.7]
b. Jul 1895
+
Cleo Potter
b. 1896
+
Mary Emma Herrick
b. 20 Mar 1865 d. 3 Jun 1938
10
Nora Horton
[1.2.1.2.1.1.5.7.6.3]
b. 1866 d. 1957
Fred Tobias
b. 18 Mar 1863 d. 28 Sep 1932
11
Archie Bird Tobias
[1.2.1.2.1.1.5.7.6.3.1]
b. 1889 d. Oct 1968
10
Albert F Horton, Jr
[1.2.1.2.1.1.5.7.6.4]
b. 21 Feb 1868 d. 5 Jul 1938
+
Nancy Putman
b. 14 Jan 1872 d. 3 Sep 1902
10
Minnie Letty Horton
[1.2.1.2.1.1.5.7.6.5]
b. 17 Dec 1869 d. 6 Jul 1964
+
George A Rix
b. 11 Oct 1873 d. 27 Oct 1951
10
Jennie A Horton
[1.2.1.2.1.1.5.7.6.6]
b. Dec 1871 d. 1956
Guy Madison Litchfield
b. 27 May 1870 d. 1 Aug 1941
11
Florence Litchfield
[1.2.1.2.1.1.5.7.6.6.1]
b. 29 May 1893 d. 19 Apr 1985
+
Faye Wilkins Allen
b. 11 Nov 1891 d. 1953
10
Floyd Myron Horton
[1.2.1.2.1.1.5.7.6.7]
b. May 1874 d. 18 May 1949
+
Eliza Ray
b. 23 Dec 1876 d. 9 Jul 1928
9
Elvira C Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.7]
b. 20 Feb 1835 d. 4 Nov 1905
Daniel Harris Crowningshield
b. 28 Oct 1827 d. 30 Nov 1911
10
Cordine H Crowningshield
[1.2.1.2.1.1.5.7.7.1]
b. 1867
10
Theda Elnora "Nora" Crowningshield
[1.2.1.2.1.1.5.7.7.2]
b. 10 Nov 1870 d. 18 Jan 1949
George Henry Fahnestock
b. 28 Jan 1874 d. 30 Dec 1954
11
Dewey Fahnestock
[1.2.1.2.1.1.5.7.7.2.1]
b. 29 Aug 1899 d. 8 Jan 1961
11
Clifford Roy Fahnstock
[1.2.1.2.1.1.5.7.7.2.2]
b. 8 Oct 1901 d. 13 Nov 1981
11
Harold "Ike" Fahnestock
[1.2.1.2.1.1.5.7.7.2.3]
b. 10 Jan 1905 d. Feb 1982
11
Floyd Hubert Fahnestock
[1.2.1.2.1.1.5.7.7.2.4]
b. 22 Apr 1909 d. 15 Feb 1911
9
Simon Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.8]
b. 1839 d. 8 Oct 1902
Alice Minerva Maxwell
b. Oct 1846 d. 29 Aug 1908
10
Ambers Simon "Ambrose" Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.8.1]
b. 10 Dec 1864 d. 8 Feb 1932
Ellen K Ross
b. 11 Jun 1869 d. 19 Sep 1943
11
Hugh Lee Roy Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.8.1.1]
b. 1 Jul 1890 d. 14 Jan 1964
11
Carl Leslie Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.8.1.2]
b. 4 Aug 1895 d. 11 Nov 1966
Helen Eleanor Wojciechowski
b. 9 Sep 1897 d. 9 Oct 1973
12
Living
[1.2.1.2.1.1.5.7.8.1.2.1]
12
Robert Lawrence Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.8.1.2.2]
b. 19 Feb 1920 d. 22 Apr 1922
11
Grace Leona Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.8.1.3]
b. 1903 d. 7 Jul 1943
+
Thomas Frederick Mawer
b. 1896
11
Ross Laverne Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.8.1.4]
b. 7 Apr 1906 d. 14 Nov 1973
Marie Liszkowski
b. 7 Sep 1909 d. 10 Mar 1983
12
Living
[1.2.1.2.1.1.5.7.8.1.4.1]
12
Living
[1.2.1.2.1.1.5.7.8.1.4.2]
10
Minerva May "Minnie" Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.8.2]
b. 4 Jul 1866 d. 29 Oct 1954
Eugene Leonard Snell
b. 17 Jan 1862 d. 30 Apr 1949
11
Ola May Snell
[1.2.1.2.1.1.5.7.8.2.1]
b. 1889 bur. Jun 1975
Llewellyn Marton Rhodes
b. 1873
12
Lee Mertin Rhodes
[1.2.1.2.1.1.5.7.8.2.1.1]
b. 30 Jan 1925 d. 21 Dec 2003
12
Wayne Snell Rhodes
[1.2.1.2.1.1.5.7.8.2.1.2]
b. 9 Sep 1927 d. 28 Jul 2010
11
Eva Lena Snell
[1.2.1.2.1.1.5.7.8.2.2]
b. 23 Dec 1891
+
Norman C Colebrook
b. Oct 1893
11
Otis R Snell
[1.2.1.2.1.1.5.7.8.2.3]
b. 1894 d. 19 Feb 1985
11
Eldie S Snell
[1.2.1.2.1.1.5.7.8.2.4]
b. 1896
+
Blanche M Graham
b. 1896
11
Alice B Snell
[1.2.1.2.1.1.5.7.8.2.5]
b. 1900 d. 20 Jul 1983
11
Caroline C "Carrie" Snell
[1.2.1.2.1.1.5.7.8.2.6]
b. 1903
+
Thomas E Langford
b. 1903
10
Cora M Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.8.3]
b. Jan 1868 d. 29 Feb 1908
+
George Lewis Friend
b. Jan 1868 d. 29 Feb 1908
10
Myrtle Louella "Marties" Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.8.4]
b. 13 Oct 1872 d. 5 Dec 1944
Fred L Euga
b. 8 Aug 1870 d. 16 Dec 1948
11
Vivian A Euga
[1.2.1.2.1.1.5.7.8.4.1]
b. 1906 d. 1906
11
Ellen W Euga
[1.2.1.2.1.1.5.7.8.4.2]
b. 1907 d. 1908
10
Llewellyn Merton "Mertie" Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.8.5]
b. 13 Oct 1872 d. 20 Dec 1940
10
William Henry Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.8.6]
b. 21 Sep 1875 d. 16 Mar 1925
Eda Altha Hockert
b. 13 Oct 1881 d. 31 Dec 1939
11
Dayton L Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.8.6.1]
b. 24 Jun 1903 d. 29 Nov 1903
11
Orba William Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.8.6.2]
b. 31 Dec 1904 d. 4 Aug 1912
11
Russell Ara Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.8.6.3]
b. 23 Feb 1906 d. 27 Dec 1943
11
Irene Genevieve Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.8.6.4]
b. 2 Jun 1907 d. 2001
11
Hazel May Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.8.6.5]
b. 2 Jun 1907 d. 2004
+
Emil Messmer
b. 12 Jul 1895 d. 4 Apr 1971
11
Lawrence Gilbert Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.8.6.6]
b. 6 May 1911 d. 2 Mar 1998
+
Jessie Cairns Craigon Brown
b. 1913 d. 2012
11
Altha Ione Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.8.6.7]
b. 13 Nov 1913 d. Jun 2009
11
Eda Alice Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.8.6.8]
b. 13 Oct 1915 d. 19 Dec 1939
11
Living
[1.2.1.2.1.1.5.7.8.6.9]
11
Ruth Effie Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.7.8.6.10]
b. 1924 d. 2001
8
Polly Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.8]
b. 1797
8
Adin Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.9]
b. 1800 d. 6 May 1830
Angelina Houghton
b. 26 Aug 1801 d. 6 May 1891
9
Milo Pettibone Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.9.1]
b. 1821 d. 26 Feb 1844
9
Emery Seymoor Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.9.2]
b. 1823 d. 8 Dec 1825
9
Edwin Oscar Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.9.3]
b. 15 Dec 1824 d. 13 Sep 1901
9
Amelia Emeline Bennett
[1.2.1.2.1.1.5.9.4]
b. 26 Oct 1827 d. 3 Feb 1918
Charles Parker
b. 1822 d. 25 Aug 1895
10
Esther Parker
[1.2.1.2.1.1.5.9.4.1]
b. 1849
10
Mary Angeline Parker
[1.2.1.2.1.1.5.9.4.2]
b. 3 May 1849 d. 14 Jun 1919
Albert Bingham Woodworth
b. 7 Apr 1843 d. 24 Jun 1908
11
Edward Knowlton Woodworth
[1.2.1.2.1.1.5.9.4.2.1]
b. 25 Aug 1875 d. 28 Sep 1938
Clara Elizabeth Farwell Holt
b. 22 May 1879 d. 20 Jul 1917
12
Constance Woodworth
[1.2.1.2.1.1.5.9.4.2.1.1]
b. 10 May 1906 d. 27 Aug 1994 [
=>
]
12
Elizabeth Woodworth
[1.2.1.2.1.1.5.9.4.2.1.2]
b. 9 Apr 1909 d. 14 Aug 1922
12
Margaret Woodworth
[1.2.1.2.1.1.5.9.4.2.1.3]
b. 5 Aug 1912 d. 2 Jul 1997 [
=>
]
12
Mary Woodworth
[1.2.1.2.1.1.5.9.4.2.1.4]
b. 19 Jul 1917 d. 12 Feb 2008 [
=>
]
12
Daughter Woodworth
[1.2.1.2.1.1.5.9.4.2.1.5]
b. 20 Jul 1917 d. 20 Jul 1917
+
Kate Chandler
b. 21 Oct 1871 d. 23 Aug 1926
11
Grace Woodworth
[1.2.1.2.1.1.5.9.4.2.2]
b. Oct 1879
+
Isaac Hill
b. 3 Sep 1869 d. 1 Jul 1933
11
Charles Parker Woodworth
[1.2.1.2.1.1.5.9.4.2.3]
b. 8 Jul 1885 d. 16 Feb 1967
Sarah Cheney Fish
b. 10 May 1889 d. 20 Nov 1991
12
Sarah "Sally" Woodworth
[1.2.1.2.1.1.5.9.4.2.3.1]
b. 25 Jan 1922 d. 29 Jul 2013
10
Joseph Parker
[1.2.1.2.1.1.5.9.4.3]
b. 1851
10
Charles E Parker
[1.2.1.2.1.1.5.9.4.4]
b. 1851 d. 1852
10
Harry Elwood Parker
[1.2.1.2.1.1.5.9.4.5]
b. 11 Jun 1853 d. 12 May 1933
Anne Marie Weston
b. 4 Jun 1851 d. 26 Feb 1920
11
Leslie Wilson Parker
[1.2.1.2.1.1.5.9.4.5.1]
b. 26 Apr 1877 d. 28 Feb 1878
11
Katherine Louise Parker
[1.2.1.2.1.1.5.9.4.5.2]
b. 9 Jul 1879 d. 17 Oct 1945
William Spooner Huntington
b. 15 Jan 1871 d. 16 Feb 1951
12
Parker Huntington
[1.2.1.2.1.1.5.9.4.5.2.1]
b. 15 Jan 1901 d. 12 Dec 1984
11
Sara Knowles Parker
[1.2.1.2.1.1.5.9.4.5.3]
b. 3 Dec 1881 d. 21 Apr 1952
11
Charles Parker
[1.2.1.2.1.1.5.9.4.5.4]
b. 1 Jul 1884 d. 27 Feb 1954
Mabel Alma Martin
b. 3 Oct 1885 d. 24 Nov 1946
12
Harry Elwood Parker
[1.2.1.2.1.1.5.9.4.5.4.1]
b. 29 Jun 1917 d. 6 Oct 1995
12
Charles Parker
[1.2.1.2.1.1.5.9.4.5.4.2]
b. 21 Aug 1923 d. 17 Jun 2011 [
=>
]
11
Levi Houghton Parker
[1.2.1.2.1.1.5.9.4.5.5]
b. 5 Jan 1891 d. 8 Oct 1918
Bernice Dodge
b. Mar 1893 d. 19 Jan 1986
12
Charles Parker
[1.2.1.2.1.1.5.9.4.5.5.1]
b. 12 Jul 1918 d. 13 Jul 2004 [
=>
]
10
Grace E A Parker
[1.2.1.2.1.1.5.9.4.6]
b. 29 Jun 1860
Thomas Julian Walker, Jr
b. 12 Mar 1856 d. 13 Jan 1911
11
Shirley Penn Walker
[1.2.1.2.1.1.5.9.4.6.1]
b. 19 Dec 1884 d. 31 Jul 1936
Clark Porter Chandler
b. 30 Mar 1886 d. 4 Sep 1936
12
William Eaton Chandler
[1.2.1.2.1.1.5.9.4.6.1.1]
b. 28 Oct 1908 d. 7 Oct 2005 [
=>
]
12
Thomas Walker Chandler
[1.2.1.2.1.1.5.9.4.6.1.2]
b. 3 Dec 1911 d. 19 Sep 1945
12
Stuart Penn Chandler
[1.2.1.2.1.1.5.9.4.6.1.3]
b. Jan 1915 d. 25 Jun 1919
11
Anne M Walker
[1.2.1.2.1.1.5.9.4.6.2]
b. 15 Sep 1886 d. Apr 1969
+
Stuart Durland Warner
b. 24 Jul 1886 d. Apr 1965
7
Richard Bennett
[1.2.1.2.1.1.6]
b. 6 Feb 1732 d. 1786
Hannah Goad
b. 7 Apr 1725 d. 1770
7
Benjamin Bennett
[1.2.1.2.1.1.7]
b. 1735 d. 1783
7
Thomas Fullalove Bennett
[1.2.1.2.1.1.8]
b. 1742 d. 6 Feb 1809
7
Stephen Bennett
[1.2.1.2.1.1.9]
b. 1744 d. 1826
7
Sarah Bennett
[1.2.1.2.1.1.10]
b. 1744 d. 1805
7
James William Bennett
[1.2.1.2.1.1.11]
b. 25 Jun 1745 d. 21 May 1826
6
Peter Bennett
[1.2.1.2.1.2]
b. 7 Nov 1704 d. 12 Feb 1726
6
Elizabeth Bennett
[1.2.1.2.1.3]
c. 2 Mar 1707
6
Richard Bennett
[1.2.1.2.1.4]
c. 1 May 1709 d. 1786
Elizabeth Rice
b. Abt 1710 d. 1774
7
Rice Bennett
[1.2.1.2.1.4.1]
b. 1726 d. 24 Aug 1772
Sarah Hampton
b. 1733 d. 19 Sep 1796
8
Mary Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.1]
b. Abt 1753
8
William Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2]
b. Abt 1755 d. May 1823
Catherine Bernard
b. 1758 d. Feb 1831
9
Mary Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.1]
b. 6 Mar 1776 d. 16 Aug 1847
9
Elisha Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.2]
b. Abt 1777 d. Bef 14 Oct 1839
9
Elizabeth Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.3]
b. 23 Aug 1782
9
Richard Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.4]
b. 30 Mar 1785 d. 30 Aug 1835
+
Mary Bell
b. 5 Dec 1786 d. 12 Apr 1856
9
Martha Jane Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.5]
b. Abt 1786 d. 20 Oct 1871
9
Lucy Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.6]
b. Abt 1788 d. Aft 1850
9
William Junior Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7]
b. 22 Jul 1790 d. 1 Oct 1846
Elizabeth Bell
b. 4 Nov 1792 d. 5 Nov 1864
10
Austin Bell Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.1]
b. 11 Dec 1814 d. 8 Jul 1896
Angelina Storm
b. 8 Nov 1818 d. 25 Sep 1854
11
John J Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.1.1]
b. Abt 1839
Nancy Ann Sexton
b. 1843 d. Bef 1888
12
Lillian Viola Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.1.1.1]
b. 16 Sep 1870 d. May 1965 [
=>
]
12
Eddie Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.1.1.2]
b. Abt 1877
11
Eli Preston Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.1.2]
b. Abt 1840
Allie Sexton
b. 21 Oct 1840
12
Caroline Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.1.2.1]
b. 1863 d. Abt 1924 [
=>
]
12
Defert Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.1.2.2]
b. 1865 [
=>
]
11
Sarah Ann Elizabeth Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.1.3]
b. 14 Aug 1842 d. 30 Apr 1934
George Jasper Curry
b. 30 Sep 1840 d. 15 Dec 1935
12
Angelina Curry
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.1.3.1]
b. 3 Sep 1861 d. 21 Mar 1897 [
=>
]
12
William Edward Curry
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.1.3.2]
b. 27 Feb 1865 d. 5 Dec 1937 [
=>
]
12
Martha Ella Curry
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.1.3.3]
b. Abt Dec 1867 d. 29 Aug 1949 [
=>
]
12
Fanny Curry
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.1.3.4]
b. 19 Mar 1871 d. 21 Oct 1936
12
Myrtle Ethel Mirty Curry
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.1.3.5]
b. 24 Aug 1879 d. 3 Jul 1971
12
Ora Curry
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.1.3.6]
b. Abt 1880 d. Abt 1935
12
Silas Curry
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.1.3.7]
b. 25 May 1882 d. 27 Mar 1968
11
Adolphus J Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.1.4]
b. 1842
+
Emaline Hart
b. Abt 1846
11
Samuel Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.1.5]
b. Abt 1847 d. Abt 1919
+
Hannah J Jones
b. Abt 1840 d. 29 Sep 1859
Sarah Amanda Moore
b. Abt 1842 d. 24 Nov 1917
12
George Douglas Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.1.5.1]
b. 1862 d. 5 Sep 1910 [
=>
]
12
Cora Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.1.5.2]
b. 1865
12
Edwin D Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.1.5.3]
b. 6 Mar 1868 d. 18 Sep 1956 [
=>
]
12
William Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.1.5.4]
b. 1869
12
Grace Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.1.5.5]
b. Nov 1881
11
William Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.1.6]
b. 1848 d. Bef 1896
Barbara A Camp
b. 1851
12
Henry Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.1.6.1]
b. 1869
11
David L Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.1.7]
b. 14 Jun 1851 d. 13 Dec 1932
11
Vina J Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.1.8]
b. 1854 d. 6 Oct 1854
Lucretia Jane Aldridge
b. 8 Feb 1831 d. 5 Mar 1910
11
Mary Angeline Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.1.9]
b. 1857
William Forbes
b. 1847
12
Ira William Forbes
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.1.9.1]
b. Mar 1884 d. 1969
12
Ethel Forbes
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.1.9.2]
b. 1890 d. 13 May 1914
12
John Forbes
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.1.9.3]
b. 30 Jun 1891 d. 18 Mar 1941
11
Thomas F Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.1.10]
b. 1860 d. Bef 1896
+
Myrtella Hopkins
11
Eliza Jane Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.1.11]
b. 1862
Franklin Sexton
b. Abt 1861
12
Nary Sexton
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.1.11.1]
b. Abt 1881
12
Cleman Sexton
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.1.11.2]
b. Abt 1896
12
Earnest Sexton
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.1.11.3]
b. Abt 1899 d. 1999
11
Hiram Washington Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.1.12]
b. 1866 d. 21 Jun 1910
Minnie Malinda Curry
b. 1876
12
Ralph C Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.1.12.1]
b. 1898 d. 1961
12
Howard G Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.1.12.2]
b. 1902 d. 1967
11
Patrick Henry Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.1.13]
b. 1869 d. 1946
Annie I Lutz
b. 1874 d. 17 Aug 1928
12
Mary E Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.1.13.1]
b. 1904
10
Thomas McGuire Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.2]
b. 24 Feb 1816 d. 24 Feb 1894
Sarah Bennett
b. 1815
11
Elizabeth E Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.2.1]
b. 22 Jan 1837 d. 2 May 1911
William C Hendrixson
b. 1832
12
Carol Hendrickson
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.2.1.1]
b. 1860
12
Sarah Hendrickson
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.2.1.2]
b. 1860
12
Henry Hendrickson
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.2.1.3]
b. 3 Oct 1860 d. 29 Apr 1929
12
Henry C Hendrickson
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.2.1.4]
b. 3 Oct 1860 d. 29 Apr 1929
+
William Cooksey Caldwell
b. 26 Mar 1826 d. 1 Sep 1900
11
Thomas J Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.2.2]
b. Nov 1839
11
Margaret F Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.2.3]
b. 1842
+
Felty Culwell
b. 1838
11
James Washington Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.2.4]
b. 25 Jul 1857 d. 25 Apr 1920
Nancy Catherine Anderson
b. 8 Sep 1854 d. 2 Apr 1940
12
Julia Florence Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.2.4.1]
b. 1879 d. 1912 [
=>
]
12
William Roland Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.2.4.2]
b. 22 Nov 1879 [
=>
]
Margaret Lavina Wilson
b. 22 Feb 1815 d. 30 Oct 1907
11
William Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.2.5]
b. 25 May 1849 d. 23 Aug 1904
Elizabeth Ann Sansom
b. 6 Aug 1853 d. 25 May 1933
12
William Thomas Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.2.5.1]
b. 29 Oct 1875 d. 7 Sep 1877
12
James Walter Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.2.5.2]
b. 28 Dec 1878 d. 8 Jan 1908 [
=>
]
12
Henry Leroy Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.2.5.3]
b. 10 Nov 1880 d. 10 May 1963 [
=>
]
12
Edith Ann Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.2.5.4]
b. 9 Mar 1882 d. 12 Sep 1966 [
=>
]
12
Sarah Elizabeth Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.2.5.5]
b. 6 Feb 1893 d. 2 Jun 1960 [
=>
]
10
Sarah Ann Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.3]
b. 8 Oct 1817
10
Eliza Catherine Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.4]
b. 19 Jan 1819
Samuel Downes
b. 1830 d. 16 Jan 1894
11
Samuel Downes
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.4.1]
b. 1854
11
Elizabeth Downes
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.4.2]
b. 1856
11
Arthur Downes
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.4.3]
b. 1857
Harriett Sarah Manns
b. Abt 1861
12
Clara May Downes
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.4.3.1]
b. 6 Mar 1893 d. Jan 1971 [
=>
]
11
Frederick Downes
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.4.4]
b. 1860
10
Mary Jane Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.5]
b. 1 Jan 1821 d. 25 Jun 1852
Jesse Temple McCauslin
b. 24 Feb 1817 d. 6 Mar 1884
11
William Y McCauslin
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.5.1]
b. Abt 1850 d. 8 Apr 1865
11
Sally McCauslin
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.5.2]
b. Abt 1848 d. 26 Jun 1852
10
Hiram Bell Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6]
b. 1 Mar 1823 d. 17 Aug 1912
Martha Smith
b. 9 Jun 1817 d. 12 Oct 1902
11
Henry Bell Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.1]
b. Jun 1846 d. Jun 1846
11
Hyrum William Asahel Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.2]
b. 22 Nov 1848 d. 9 Jan 1849
11
Martha Eliza Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.3]
b. 24 Jan 1849 d. 6 May 1924
Silas Sanford Smith, Jr
b. 26 Oct 1830 d. 11 Oct 1910
12
Sarah Ann Smith
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.3.1]
b. 11 Jul 1868 d. 2 Feb 1900
12
Martha Eliza Smith
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.3.2]
b. 17 Mar 1870 d. 7 Jan 1957 [
=>
]
12
Curtis Bennett Smith
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.3.3]
b. 23 Oct 1871 d. 28 Nov 1942
12
Elias Austin Smith
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.3.4]
b. 4 Mar 1874 d. 27 Jun 1925 [
=>
]
12
Emma Jane Smith
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.3.5]
b. 4 Apr 1876 d. 16 Jan 1951 [
=>
]
12
George Essex Smith
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.3.6]
b. 24 Sep 1878 d. 26 May 1949 [
=>
]
12
Erastus Snow Smith
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.3.7]
b. 18 Aug 1881 d. 16 Sep 1890
12
Hyrum Asahel Smith
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.3.8]
b. 15 Sep 1883 d. 16 Jul 1941 [
=>
]
12
Lucy Edith Smith
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.3.9]
b. 12 Aug 1886 d. 6 Jan 1963 [
=>
]
12
Joseph Frances Smith
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.3.10]
b. 7 Apr 1889 d. 14 Feb 1920 [
=>
]
12
Clara Estella Smith
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.3.11]
b. 4 Aug 1891 d. 10 May 1992
12
Verlie Dorcas Smith
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.3.12]
b. 14 Oct 1894 d. 23 Dec 1894
11
Ezra Melanthorn Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.4]
b. 20 Oct 1851 d. 25 Aug 1852
11
Emily Jane Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.5]
b. 17 Jan 1854 d. 4 May 1903
John Aikens Smith
b. 19 Mar 1854 d. 9 Jan 1923
12
Emily Jane Smith
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.5.1]
b. 5 May 1878 d. 21 Feb 1958 [
=>
]
12
Sarah Ann Smith
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.5.2]
b. 23 Apr 1883 d. 22 Feb 1969 [
=>
]
12
Mary Hortense Smith
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.5.3]
b. 19 Dec 1884 d. 8 Jun 1885
12
Martha Eliza Smith
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.5.4]
b. 23 Aug 1886 d. 2 Apr 1980 [
=>
]
12
John Aikens Smith
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.5.5]
b. 5 Oct 1888 d. 4 Apr 1970 [
=>
]
12
Lucy Elizabeth Smith
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.5.6]
b. 24 May 1893 d. 23 Oct 1944
11
Elizabeth Emma Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.6]
b. 2 Jul 1856 d. 26 Feb 1940
Joseph Henry Fisher
b. 18 Oct 1856 d. 21 Nov 1940
12
Zina Elizabeth Fisher
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.6.1]
b. 6 Nov 1880 d. 14 Feb 1890
12
Martha Hannah Lees Fisher
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.6.2]
b. 19 Feb 1882 d. 23 May 1958 [
=>
]
12
Mary Emily Fisher
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.6.3]
b. 25 Oct 1883 d. 18 Feb 1890
12
Joseph Lees Fisher
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.6.4]
b. 5 Oct 1885 d. 14 Feb 1890
12
Albert Hyrum Fisher
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.6.5]
b. 28 Dec 1888 d. 10 Jul 1973 [
=>
]
12
Angie Celestine Fisher
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.6.6]
b. 2 May 1893 d. 25 Nov 1971 [
=>
]
12
James Clyde Fisher
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.6.7]
b. 5 Jun 1896 d. 19 Nov 1977
12
Cecil Neil Fisher
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.6.8]
b. 8 Jul 1898 d. 2 Oct 1983 [
=>
]
11
Elias Austin Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.7]
b. 26 Jan 1858 d. 1 May 1861
Ellen Greenhalgh
b. 27 Jul 1851 d. 4 May 1890
11
Jesse Johnson Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.8]
b. 25 Jul 1869 d. 22 Sep 1949
Rachel Dena Beckstrand
b. 11 Apr 1876 d. 25 Dec 1966
12
Dr. Jesse Lamar Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.8.1]
b. 16 Jun 1901 d. 3 Feb 1979 [
=>
]
12
Leeman Bell Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.8.2]
b. 6 Jan 1904 d. 3 Aug 1992 [
=>
]
12
Marvin Elias Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.8.3]
b. 6 May 1908 d. 9 Jun 1908
12
Lowell Rex Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.8.4]
b. 13 Feb 1910 d. 25 Sep 1981 [
=>
]
12
Ivan Osborn Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.8.5]
b. 28 Nov 1912 d. 16 Aug 1958 [
=>
]
12
Vance Wilson Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.8.6]
b. 9 Jun 1916 d. 27 Jun 2006
11
George Alfred Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.9]
b. 27 Apr 1871 d. 27 Apr 1943
Bessie Maria Labrum
b. 23 Nov 1874 d. 26 Jul 1959
12
Avera Joy Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.9.1]
b. 6 Apr 1897 d. 13 Dec 1982 [
=>
]
12
Nolan Henry Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.9.2]
b. 19 Oct 1905 d. 2 Jan 1996 [
=>
]
Julia Ann Reay
b. 10 Sep 1891 d. 23 Aug 1956
12
Mary Ellen Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.9.3]
b. 30 Aug 1911 d. 17 Dec 1979
12
Living
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.9.4]
11
Sarah Ellen Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.10]
b. 9 Feb 1873 d. 13 Jun 1961
Joseph Lees Stott
b. 25 Jun 1872 d. 27 May 1923
12
Joseph Leo Stott
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.10.1]
b. 28 Oct 1894 d. 25 Aug 1959 [
=>
]
12
Cleon Bennett Stott
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.10.2]
b. 23 Aug 1896 d. 17 Apr 1961 [
=>
]
12
Melba Ellen Stott
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.10.3]
b. 2 Sep 1898 d. 15 Jan 1987 [
=>
]
11
Esther Pricilla Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.11]
b. 20 Sep 1874 d. 1 Apr 1966
11
Mary Alice Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.12]
b. 4 Nov 1876 d. 17 Jun 1972
John Charles Labrum
b. 15 May 1877 d. 11 Jul 1943
12
Venoy Bennett Labrum
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.12.1]
b. 2 Jul 1899 d. 14 Nov 1982 [
=>
]
12
Cyril Jay Labrum
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.12.2]
b. 12 Jul 1901 d. 23 Aug 1973 [
=>
]
12
Glade C Labrum
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.12.3]
b. 21 Aug 1908 d. 27 Oct 1967
12
Medra Alice Labrum
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.12.4]
b. 26 Sep 1910 d. 15 Oct 2000 [
=>
]
11
Lucy Belle Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.13]
b. 4 Jul 1878 d. 6 Feb 1968
William George Adams
b. 13 May 1877 d. 31 Aug 1954
12
Glenda Adams
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.13.1]
b. 29 Dec 1907 d. 10 Jul 1973
12
Lucy Larue Adams
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.13.2]
b. 3 May 1909 d. 13 Jan 1983
12
Pearl Ellen Adams
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.13.3]
b. 23 Nov 1910 d. 8 Oct 1991
12
Salina Marinda Adams
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.13.4]
b. 6 Oct 1913 d. 3 Feb 1993
12
William Stanford Adams
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.13.5]
b. 13 Aug 1915 d. 8 Jul 1998 [
=>
]
12
Ina Adams
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.13.6]
b. 19 Oct 1918 d. 7 Dec 1991
12
Percival Adams
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.13.7]
b. 12 Oct 1920 d. 11 Jul 1997
11
Minnie Margaret Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.14]
b. 15 Apr 1880 d. 29 Jul 1961
Peter Wilford Pearson
b. 10 Dec 1877 d. 30 May 1969
12
Ursula Pearson
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.14.1]
b. 17 Jul 1902 d. 9 May 1970
12
Eric Bennett Pearson
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.14.2]
b. 12 Jan 1904 d. 2 Jan 1982
12
Luzene Pearson
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.14.3]
b. 14 Oct 1906 d. 4 Jan 1999
12
Carrie Ellen Pearson
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.14.4]
b. 6 Jul 1909 d. 18 Dec 1985
12
Wilford August Pearson
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.14.5]
b. 1 Jun 1914 d. 8 Jan 1993
12
Margaret Pearson
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.14.6]
b. 16 Sep 1915 d. 30 Apr 2008 [
=>
]
11
Clara Marinda Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.15]
b. 3 Feb 1883 d. 27 Sep 1966
+
Anton Johan Theodor Sorensen
b. 1 Mar 1877 d. 29 Jun 1974
11
Edith Ann Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.16]
b. 3 Jan 1885 d. 9 Jul 1947
Isaac Ernest Bushnell
b. 18 Mar 1885 d. 9 Jul 1947
12
Weldo Bell Bushnell
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.16.1]
b. 15 May 1908 d. 28 Nov 1972 [
=>
]
12
Edith Loretta Bushnell
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.16.2]
b. 19 Sep 1909 d. 3 Mar 2000 [
=>
]
12
Belva E Bushnell
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.16.3]
b. 31 Oct 1910 d. 4 Mar 1995 [
=>
]
12
Ural J Bushnell
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.16.4]
b. 19 Feb 1912 d. 22 Sep 1975 [
=>
]
12
Beatrice Vernell Bushnell
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.16.5]
b. 17 Mar 1917 d. 31 Jul 1997 [
=>
]
12
Ruth Bushnell
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.16.6]
b. 7 Oct 1919 d. 4 Feb 2006
12
Lola B Bushnell
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.16.7]
b. 25 Feb 1914 d. 14 Jan 1997 [
=>
]
11
Albert Eli Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.17]
b. 20 Mar 1887 d. 11 Aug 1953
Ruth Ellen Stewart
b. 24 Aug 1889 d. 8 Sep 1968
12
Ila Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.17.1]
b. 3 Apr 1912 d. 25 Jun 2006 [
=>
]
12
Eli Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.17.2]
b. 25 Jul 1923 d. 25 Jul 1923
11
Peter Preston Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.18]
b. 4 Oct 1888 d. 1 Dec 1967
Mary Edith Lee
b. 10 Jan 1888 d. 13 Sep 1976
12
Audrey Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.18.1]
b. 30 Dec 1912 d. 2 Feb 1997
12
Ida Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.18.2]
b. 28 Jan 1917 d. 18 Feb 1917
12
Max Miles Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.18.3]
b. 27 Jul 1921 d. 8 Nov 1998
12
Ada Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.18.4]
b. 16 Aug 1925 d. 21 Aug 2001
12
Gary Lee Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.6.18.5]
b. 12 May 1931 d. 14 Sep 2002
10
William M Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.7]
b. 4 Nov 1824
10
Martha Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.8]
b. 4 Jun 1825 d. 25 Dec 1867
William James Calkins
b. 17 Oct 1822 d. 10 Jun 1892
11
Eliza Ann Calkins
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.8.1]
b. 28 Jan 1854 d. 26 May 1930
Francis Marion Elmer
b. 11 Nov 1848 d. 15 Apr 1916
12
Francis Arden Elmer
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.8.1.1]
b. 16 Feb 1874 d. 21 Oct 1940 [
=>
]
12
William Denver Elmer
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.8.1.2]
b. 19 Feb 1876 d. 5 Feb 1878
12
Hyrum King Elmer
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.8.1.3]
b. 31 Oct 1877 d. 3 Dec 1937 [
=>
]
12
John Harvey Elmer
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.8.1.4]
b. 20 Jul 1879 d. 27 Sep 1950 [
=>
]
12
Martha Viola Elmer
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.8.1.5]
b. 26 Aug 1881 d. 11 Mar 1951 [
=>
]
12
Albert Earl Elmer
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.8.1.6]
b. 4 Apr 1885 d. 4 Nov 1959 [
=>
]
12
Arthur Lee Elmer
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.8.1.7]
b. 4 Feb 1887 d. 5 Dec 1963 [
=>
]
12
Daniel Hale Elmer
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.8.1.8]
b. 19 Mar 1891 d. 29 Nov 1928 [
=>
]
12
Ada Mercedas Elmer
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.8.1.9]
b. 19 Apr 1893 d. 7 Dec 1970 [
=>
]
11
Martha Emeline Calkins
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.8.2]
b. Abt 1858 d. 1860
11
William Cyril Calkins, Jr
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.8.3]
b. 10 Aug 1864 d. 10 Jul 1929
Mary Elizabeth Hartness
b. 28 Mar 1854 d. 23 Jan 1927
12
Sarah Jane Calkins
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.8.3.1]
b. 25 Apr 1881 d. 8 Feb 1966 [
=>
]
12
Maude Calkins
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.8.3.2]
b. 4 Apr 1883
12
Charles Calkins
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.8.3.3]
b. Abt Jun 1885
12
William Gold Gordon Calkins
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.8.3.4]
b. 7 Feb 1891 d. 4 Nov 1946 [
=>
]
12
Marvel Calkins
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.8.3.5]
b. 29 Aug 1894
12
Wilford Cyril Calkins
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.8.3.6]
b. 26 Jan 1896 d. 12 Jan 1961
11
Alfred Arden Calkins
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.8.4]
b. 23 Dec 1867 d. 26 Dec 1867
10
George Alfred Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.9]
b. 4 May 1828 d. 18 Apr 1906
Lucy Ann Susan Saxey
b. 13 Jan 1842 d. 15 Jan 1892
11
Hannah Louisa Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.9.1]
b. 8 May 1860 d. 27 Aug 1921
Henry F Rinehart
b. Sep 1858 d. 29 Oct 1919
12
John Rinehart
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.9.1.1]
b. 18 May 1886 d. 19 Dec 1962
12
Lucy Ann Rinehart
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.9.1.2]
b. 5 Aug 1887 d. 9 Jul 1963 [
=>
]
12
Albert M Rinehart
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.9.1.3]
b. 11 Nov 1892 d. 7 Feb 1954 [
=>
]
12
George Rinehart
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.9.1.4]
b. 18 May 1894
12
Carl Rinehart
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.9.1.5]
b. 17 Jan 1896 [
=>
]
12
Fred Rinehart
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.9.1.6]
b. Sep 1899
11
John Alfred Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.9.2]
b. 1 Jul 1864 d. 24 Jul 1948
Laura Amanda Sharp
b. 16 Mar 1882 d. 11 Mar 1945
12
Verner Alfred Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.9.2.1]
b. 19 Mar 1900 d. 27 Sep 1962 [
=>
]
12
Robert Earl Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.9.2.2]
b. 19 Aug 1901 d. 26 Mar 1946
12
Howard Leslie Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.9.2.3]
b. 11 Jul 1904 d. 5 Feb 1988 [
=>
]
12
Ila Lucy Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.9.2.4]
b. 5 Mar 1907 d. 20 May 1908
12
Iva Lucinda Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.9.2.5]
b. 5 Mar 1907 d. 27 Aug 1978
12
Eunita Roberta Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.9.2.6]
b. 16 Feb 1909 d. 1 Jul 1974 [
=>
]
12
Neoma Fern Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.9.2.7]
b. 24 Sep 1914 d. 30 Sep 1993 [
=>
]
11
Mary Ellen Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.9.3]
b. 23 Sep 1866 d. 3 Feb 1928
Joseph Taylor Simmons
b. 11 Feb 1858 d. 17 Jul 1912
12
Jodie Elliot Simmons
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.9.3.1]
b. 15 Oct 1886 d. 25 Oct 1918 [
=>
]
12
Emma Ellen Simmons
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.9.3.2]
b. 15 Feb 1888 d. 17 May 1971 [
=>
]
12
Lee Leroy Simmons
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.9.3.3]
b. 28 Mar 1890 d. 13 Jun 1969 [
=>
]
11
Elizabeth Lucy Ann Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.9.4]
b. 24 Aug 1861 d. 2 Nov 1893
Hyrum Dennis Collins
b. 3 Apr 1851 d. 15 Jul 1919
12
Ova Elizabeth Collins
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.9.4.1]
b. 8 Aug 1879 d. 3 Jun 1960 [
=>
]
12
Hilda Collins
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.9.4.2]
b. 3 Apr 1881 d. 4 Mar 1933 [
=>
]
12
Herbert Dennis Collins
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.9.4.3]
b. 14 Nov 1883 d. 30 Jan 1949 [
=>
]
12
Zelda Mary Collins
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.9.4.4]
b. 14 Oct 1885 d. 2 Mar 1953 [
=>
]
12
Annetta Collins
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.9.4.5]
b. 12 Jul 1889 d. May 1891
12
Johnathan David Collins
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.9.4.6]
b. 6 Apr 1891 d. 29 Mar 1946
12
Danial Francis Collins
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.9.4.7]
b. 5 Oct 1893 d. 20 Nov 1893
12
Nora Collins
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.9.4.8]
b. 9 Oct 1885 d. 21 Sep 1903
11
Willey Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.9.5]
b. 1869
11
George W Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.9.6]
b. 10 Dec 1869 d. 4 Jan 1936
11
Rosalle Elvira Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.9.7]
b. 15 Oct 1852 d. 20 Jul 1939
Felix Franklin Sizemore
b. 2 Jan 1869 d. 15 Aug 1944
12
Mary Ann Myrtle Sizemore
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.9.7.1]
b. 29 Nov 1895 d. 24 Sep 1976 [
=>
]
12
Frank Oran Sizemore
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.9.7.2]
b. 4 Jan 1900 d. 21 Jul 1968
12
Roy Lefonzo Sizemore
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.9.7.3]
b. 7 Jul 1908 d. 27 Jun 1985
11
William Daniel Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.9.8]
b. 10 Dec 1884 d. 18 Aug 1958
Mary Evalyn Allison
b. 1882 d. 27 Mar 1968
12
Elmer Edwin Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.9.8.1]
b. 11 Aug 1907 d. Jun 1968
12
Hurshel Gifford Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.9.8.2]
b. 20 Sep 1913 d. 6 Jan 1961
+
Mary Carline Cole
b. 25 May 1884 d. 24 Jan 1964
11
Albert Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.9.9]
b. May 1885 d. 7 Jul 1923
10
John Bell Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10]
b. 16 May 1830 d. 2 Feb 1902
Mary Senior
b. 2 Mar 1839 d. 20 May 1891
11
Mary Catherine Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.1]
b. 24 Oct 1863 d. 1864
11
John William Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.2]
b. 1864 d. 1864
11
Austin Robert Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.3]
b. 14 Jan 1866 d. 22 Sep 1942
Alice Emily Harding
b. 14 Oct 1865 d. 30 Aug 1939
12
Sarah Ethel Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.3.1]
b. 18 Apr 1888 d. 22 Dec 1966 [
=>
]
12
Clyde Austin Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.3.2]
b. 16 Jul 1889 d. 3 Nov 1988 [
=>
]
12
Leon Senior Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.3.3]
b. 13 Apr 1891 d. 28 Apr 1893
12
Mary Maude Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.3.4]
b. 13 Apr 1893 d. 3 Dec 1974 [
=>
]
12
Edward Verden Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.3.5]
b. 14 Jun 1895 d. 28 Jan 1955 [
=>
]
12
Alice Reva Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.3.6]
b. 21 Apr 1897 d. 14 Nov 1968 [
=>
]
12
John Ray Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.3.7]
b. 21 Dec 1899 d. 19 Nov 1981 [
=>
]
12
Robert Lloyd Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.3.8]
b. 28 Nov 1901 d. 18 Jul 1986 [
=>
]
12
Earl Reed Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.3.9]
b. 3 Mar 1907 d. 12 Jan 1984 [
=>
]
12
Ella Rose Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.3.10]
b. 3 Mar 1907 d. 7 Oct 1988 [
=>
]
11
Ellen Elizabeth Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.4]
b. 1867 d. 1867
11
William Hyrum Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.5]
b. 27 Oct 1869 d. 24 Apr 1947
Elizabeth Brockbank Bushnell
b. 11 Apr 1869 d. 26 Jun 1934
12
Noble William Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.5.1]
b. 27 Aug 1895 d. 10 Sep 1895
12
Sterling John Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.5.2]
b. 1 Aug 1896 d. 17 Dec 1978 [
=>
]
12
Howard Joshua Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.5.3]
b. 24 Jul 1898 d. 13 Apr 1977 [
=>
]
12
Geneva Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.5.4]
b. 16 Aug 1901 d. 17 Apr 1984 [
=>
]
12
Arvilla Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.5.5]
b. 20 Oct 1903 d. 29 Dec 1979 [
=>
]
12
Leona Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.5.6]
b. 11 Oct 1905 d. 25 Aug 1997 [
=>
]
12
Vaun Mainwaring Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.5.7]
b. 29 Mar 1911 d. 5 Apr 2004 [
=>
]
12
Edna Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.5.8]
b. 27 Aug 1913 d. 26 Oct 1995 [
=>
]
11
George Edward Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.6]
b. 19 Mar 1871 d. 3 Jan 1874
11
John Bell Bennett, Jr
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.7]
b. 11 Oct 1872 d. 28 Feb 1946
Mary Elizabeth Hustler
b. 31 Jul 1882 d. 14 Oct 1955
12
Clarence Hustler Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.7.1]
b. 2 Apr 1906 d. 8 Apr 1990 [
=>
]
12
Lyndon Senior Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.7.2]
b. 15 Jan 1908 d. 9 Jul 1986 [
=>
]
12
Leslie Powell Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.7.3]
b. 14 Oct 1909 d. 19 Sep 1989 [
=>
]
12
Stanley Bell Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.7.4]
b. 2 Nov 1914 d. 20 Apr 1987 [
=>
]
12
Marcelene Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.7.5]
b. 16 Jun 1917 d. 4 Mar 1990 [
=>
]
12
Elaine Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.7.6]
b. 12 May 1920 d. 14 Apr 1982
11
David Alfred Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.8]
b. 8 Aug 1874 d. 11 Oct 1945
Eliza May Rowley
b. 4 Jan 1875 d. 14 Dec 1959
12
Mary Ellen Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.8.1]
b. 10 Jul 1905 d. 10 Jul 1905
12
Sarah Ethel Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.8.2]
b. 10 Jul 1905 d. Jul 1905
12
Elsie Elnora Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.8.3]
b. 21 Jul 1906 d. 11 Oct 1906
12
Jennie May Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.8.4]
b. 27 Aug 1908 d. 12 Jul 1995 [
=>
]
12
Alfred Senior Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.8.5]
b. 21 Sep 1909 d. 22 Aug 1993 [
=>
]
12
Eleanor Pearl Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.8.6]
b. 25 Jun 1911 d. 7 Feb 1991 [
=>
]
12
Myrtle Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.8.7]
b. 21 Apr 1916 d. 26 Aug 2002 [
=>
]
Mary Rosella Elmina Reed
b. 17 Jan 1878 d. 27 May 1953
12
Mary Elizabeth Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.8.8]
b. 15 Sep 1897 d. 20 Jan 1965 [
=>
]
12
Evan Ensign Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.8.9]
b. 19 Aug 1899 d. 10 May 1961 [
=>
]
11
Sidney Redfern Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.9]
b. 18 Nov 1876 d. 27 Sep 1877
11
Samuel Senior Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.10]
b. 18 Nov 1876 d. 20 Jan 1951
Mary Louisa Park
b. 10 Jan 1878 d. 14 Jan 1945
12
Claude Senior Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.10.1]
b. 9 Apr 1902 d. 13 Mar 1975
12
Burl Taylor Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.10.2]
b. 8 Aug 1903 d. 13 Jul 1946
12
Melba Adene Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.10.3]
b. 24 Oct 1905 d. 5 Aug 1999
12
Cleone Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.10.4]
b. 4 Aug 1907 d. 10 Jun 1986 [
=>
]
12
Vervene Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.10.5]
b. 23 Jun 1909 d. 19 Jan 1986 [
=>
]
12
Willa Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.10.6]
b. 7 Jul 1911 d. 19 Aug 1968
12
Spencer Park Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.10.7]
b. 19 Apr 1913 d. 11 Jul 1989 [
=>
]
12
Mary Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.10.8]
b. 15 May 1917 d. 15 May 1917
12
Bruce Bell Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.10.9]
b. 13 Oct 1919 d. 26 Aug 1942
12
Living
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.10.10]
[
=>
]
+
Clara Jannette Bullock
b. 17 Jan 1877 d. 27 Mar 1966
11
Joseph McGuire Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.11]
b. 13 Sep 1878 d. 4 Jan 1944
+
Christina Besendorfer
b. 9 Mar 1895 d. 26 Mar 1971
Louisa May Rose
b. 1 May 1878 d. 30 Jan 1954
12
Floyd Kenneth Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.11.1]
b. 10 Sep 1908 d. 4 Nov 1910
12
Grant Earl Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.11.2]
b. 24 Sep 1911 d. 11 Aug 1978
11
Franklin Tennyson Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.12]
b. 21 Aug 1881 d. 25 Oct 1957
Elsie Ashworth
b. 13 Apr 1882 d. 5 May 1965
12
Erma Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.12.1]
b. 5 Feb 1906 d. 4 Jun 1965
12
Pauline Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.12.2]
b. 19 Feb 1911 d. 1 Oct 2007
12
Inez May Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.12.3]
b. 22 Nov 1913 d. 25 Feb 1994
12
Carol Elsie Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.12.4]
b. 24 Dec 1915 d. 3 Apr 1971 [
=>
]
12
Helen Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.12.5]
b. 4 Jan 1919 d. 8 Nov 1984
12
Lois Jean Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.12.6]
b. 12 Feb 1923 d. 6 Jun 2006
12
Virginia Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.10.12.7]
b. 21 Aug 1925 d. 28 Jun 2005
10
Nancy Ellen Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.11]
b. 4 Jul 1833 d. 20 Mar 1909
Jesse Temple McCauslin
b. 24 Feb 1817 d. 6 Mar 1884
11
Mary Jane McCauslin
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.11.1]
b. 16 Apr 1854 d. 14 Jul 1939
Thomas Lewis
b. 21 May 1850 d. 1 May 1885
12
Jesse Thomas Lewis
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.11.1.1]
b. Dec 1875 d. 5 Feb 1891
12
Ada McCauslin Lewis
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.11.1.2]
b. 29 Mar 1882 d. 2 May 1882
John Grier
b. 1 Oct 1838 d. 27 Mar 1907
12
Ella Reve Grier
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.11.1.3]
b. 10 Sep 1888 d. 5 Sep 1975
12
Kate Glen Grier
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.11.1.4]
b. 10 Jun 1890 d. 5 Feb 1891
12
Maggie Grier
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.11.1.5]
b. 10 Jun 1891 d. 28 Jan 1892
12
Kenneth M Grier
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.11.1.6]
b. 18 Nov 1893 d. 8 Jul 1960
11
Sarah Ann McCauslin
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.11.2]
b. 29 Aug 1855 d. 30 Jan 1932
Henry Eber Rawlings
b. 15 Oct 1851 d. 26 Dec 1924
12
Clarence Henry Rawlings
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.11.2.1]
b. 25 Nov 1877 d. 20 Feb 1945 [
=>
]
12
Hazel McCauslin Rawlings
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.11.2.2]
b. 5 May 1884 d. 29 Sep 1962 [
=>
]
12
Reva Rawlings
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.11.2.3]
b. 30 Oct 1885 bur. 9 Sep 1887
11
Lydia Ellen McCauslin
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.11.3]
b. 1 May 1856 d. 3 Sep 1858
11
Caroline McCauslin
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.11.4]
b. 14 Nov 1858 d. 23 Sep 1930
Thomas Merrill Smith
b. 12 Jan 1843 d. 17 Apr 1932
12
Florence Smith
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.11.4.1]
b. 19 Jan 1878 d. 23 Apr 1961
12
Ella Smith
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.11.4.2]
b. 16 Jul 1880 d. 20 Nov 1969 [
=>
]
12
George McCauslin Smith
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.11.4.3]
b. 12 Oct 1882 d. 11 Jan 1969 [
=>
]
12
Edwin Jay Smith
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.11.4.4]
b. 11 Apr 1886 d. 23 Sep 1911
12
Ivy Smith
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.11.4.5]
b. 9 May 1891 d. 2 Jun 1974 [
=>
]
12
Alta Elizabeth Smith
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.11.4.6]
b. 25 May 1898 d. 13 May 1976 [
=>
]
11
Jesse B McCauslin
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.11.5]
b. 13 Sep 1860 d. 16 Dec 1909
Mary Hopper
b. 13 Dec 1840 d. 15 Dec 1921
12
Jesse McCauslin
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.11.5.1]
b. 10 Sep 1881 d. 4 Dec 1952
11
George A McCauslin
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.11.6]
b. 6 Dec 1862 d. 12 Apr 1865
11
Alonzo McCauslin
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.11.7]
b. 1 May 1865 d. 22 May 1865
11
Elizabeth Mahala McCauslin
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.11.8]
b. 6 Jan 1867 d. 27 Jul 1933
John Walter Saxey
b. 14 Nov 1865 d. 8 Oct 1938
12
Albert Edward Saxey
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.11.8.1]
b. 10 Jan 1890 d. 11 Jul 1962 [
=>
]
12
Grace Elizabeth Saxey
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.11.8.2]
b. 8 Apr 1891 d. 15 Feb 1985 [
=>
]
12
Leanora Saxey
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.11.8.3]
b. 2 Feb 1893 d. 28 Jun 1966 [
=>
]
12
Nellie Saxey
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.11.8.4]
b. 1 Sep 1895 d. 31 Mar 1912
12
Mabel Saxey
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.11.8.5]
b. 4 Apr 1898 d. 17 Nov 1967
12
John Lowell Saxey
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.11.8.6]
b. 4 Dec 1900 d. 31 May 1946 [
=>
]
12
Ada Bernice Saxey
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.11.8.7]
b. 27 Mar 1902 d. 29 Mar 1991 [
=>
]
12
Wendell Alfred Saxey
[1.2.1.2.1.4.1.2.7.11.8.8]
b. 30 Sep 1905 d. 10 Nov 1980 [
=>
]
9
Clarissa Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.8]
b. Abt 1795 d. 1850
9
Catherine Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.9]
b. Abt 1796 d. Aft 1826
9
Nancy Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.2.10]
b. Abt 1797 d. Aft 1826
8
John Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.3]
b. Abt 1757 d. 6 Nov 1855
Mary Terry
b. 26 Jan 1775
9
William Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.3.1]
b. Abt 1797
9
Elizabeth Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.3.2]
b. Abt 1800
9
John R Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.3.3]
b. Abt 1803
9
Ann Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.3.4]
b. Abt 1809
+
Garner
b. Abt 1809
9
Sarah or Sally Bennett
[1.2.1.2.1.4.1.3.5]
b. Abt 1812
7
Richard Bennett, Jr
[1.2.1.2.1.4.2]
b. Abt 1732
7
John Bennett
[1.2.1.2.1.4.3]
b. Abt 1734 d. 18 Jul 1791
7
William Bennett
[1.2.1.2.1.4.4]
b. Abt 1736
7
James Bennett
[1.2.1.2.1.4.5]
b. Abt 1740
7
Fisher Rice Bennett
[1.2.1.2.1.4.6]
b. Abt 1743
5
Justephencia Bennett
[1.2.1.2.2]
b. Abt 1684
5
Sawyer Bennett
[1.2.1.2.3]
b. Abt 1686
5
Alexander Bennett
[1.2.1.2.4]
b. Abt 1688
4
Ann Bennett
[1.2.1.3]
b. Abt 1661
+
Richard E Perrin
b. 1637 d. 1 Apr 1695
4
Richard Bennett
[1.2.1.4]
b. Abt 1662
4
Mary Bennett
[1.2.1.5]
b. Abt 1665 d. Abt 1721
William Johnson
b. 29 Sep 1662 bur. Feb 1706
5
Susannah Johnson
[1.2.1.5.1]
b. 28 Jun 1688 d. 3 Jan 1735
5
Elizebeth Johnson
[1.2.1.5.2]
b. 1690 d. 11 Jan 1742
5
John Johnson
[1.2.1.5.3]
b. 1702 d. 1721
Joseph Ball
b. 24 May 1649 d. 25 Jun 1711
5
Mary Ball
[1.2.1.5.4]
b. 30 Nov 1708 d. 25 Aug 1789
Augustine Washington
b. 12 Nov 1694 d. 12 Apr 1743
6
President George Washington
[1.2.1.5.4.1]
b. 22 Feb 1732 d. 14 Dec 1799
+
Martha Dandridge
b. 2 Jun 1731 d. 22 May 1802
6
Betty Washington
[1.2.1.5.4.2]
b. 20 Jun 1733 d. 31 Mar 1797
6
Samuel Walter Washington
[1.2.1.5.4.3]
b. 16 Nov 1734 d. 26 Sep 1781
6
John Augustine Washington
[1.2.1.5.4.4]
b. 13 Jan 1737 d. 17 Feb 1787
6
Charles Washington
[1.2.1.5.4.5]
b. 2 May 1738 d. 16 Sep 1799
6
Mildred Washington
[1.2.1.5.4.6]
b. 21 Jun 1739 d. 23 Oct 1740
+
Captain Richard Hewes
b. Abt 1649 d. 1713
3
Richard Bennett
[1.2.2]
b. 21 Jan 1626 d. 21 Jan 1626
3
Philip Bennett
[1.2.3]
b. 6 Mar 1627
3
Alice Bennett
[1.2.4]
b. Abt 1629
2
Elizabeth Jane Bennett
[1.3]
b. 1602 d. 10 Mar 1681
Stephen Iggulden
b. 17 Jul 1608 d. 1634
3
John Eggleston
[1.3.1]
b. 1629 d. 1660
3
Sarah Eggleston
[1.3.2]
b. 1630 d. 10 Mar 1687
John Rawlings Nutting
b. 20 Aug 1620 d. 13 Mar 1676
4
John Rawlings Nutting, Jr
[1.3.2.1]
b. 25 Aug 1651 d. 2 Dec 1731
Mary Lakin
b. 16 Feb 1652 d. 3 Jan 1707
5
John Nutting
[1.3.2.1.1]
b. 1678 d. 1778
5
Richard Nutting
[1.3.2.1.2]
b. Abt 1684 d. Dec 1737
5
Ebenezer Nutting
[1.3.2.1.3]
b. 20 Nov 1686 d. 22 Jan 1762
5
Jonathan Nutting
[1.3.2.1.4]
b. 7 Jul 1689 d. Bef 19 May 1740
Mary Green
b. 3 Nov 1690 d. 24 Sep 1778
6
William Nutting
[1.3.2.1.4.1]
b. 20 Nov 1712 d. 2 Jun 1776
6
Sarah Nutting
[1.3.2.1.4.2]
b. 22 Feb 1714 d. 20 Jan 1799
6
Mary Nutting
[1.3.2.1.4.3]
b. 19 Nov 1718 d. Abt 1782
6
Jemina Nutting
[1.3.2.1.4.4]
b. 19 Sep 1720 d. 24 Nov 1810
6
Lydia Nutting
[1.3.2.1.4.5]
b. 20 Nov 1723 d. Nov 1812
6
Deborah Nutting
[1.3.2.1.4.6]
b. 30 Sep 1728 d. 2 Nov 1774
James Stone
b. 11 Aug 1727 d. 24 Jun 1788
7
James Stone
[1.3.2.1.4.6.1]
b. 31 May 1749 d. 21 May 1789
7
Jonathan Stone
[1.3.2.1.4.6.2]
b. 24 Oct 1750 d. 12 Aug 1795
7
Lemuel Stone
[1.3.2.1.4.6.3]
b. 23 Aug 1753 d. 1 Jun 1840
7
Mary Stone
[1.3.2.1.4.6.4]
b. 27 Sep 1755
7
Deborah Stone
[1.3.2.1.4.6.5]
b. 16 Aug 1757 d. 1791
7
William Stone
[1.3.2.1.4.6.6]
b. 20 Apr 1759 d. 18 Jul 1779
7
Eunice Stone
[1.3.2.1.4.6.7]
b. 10 Jan 1760
7
David Stone
[1.3.2.1.4.6.8]
b. 20 Oct 1761
7
Annis Stone
[1.3.2.1.4.6.9]
b. 22 Mar 1763
7
Lucy Stone
[1.3.2.1.4.6.10]
b. 16 Oct 1765 d. 22 Jun 1801
7
Hannah Stone
[1.3.2.1.4.6.11]
b. 28 Sep 1767 d. 4 Jul 1847
7
Phineas Stone
[1.3.2.1.4.6.12]
b. 22 Apr 1769
7
Josiah Stone
[1.3.2.1.4.6.13]
b. 1 Apr 1771
Sarah Daby
b. 7 Feb 1772
8
Josiah Stone
[1.3.2.1.4.6.13.1]
b. 29 Dec 1797
8
Levi Stone
[1.3.2.1.4.6.13.2]
b. 5 Sep 1799
8
Ezra Stone
[1.3.2.1.4.6.13.3]
b. 8 Dec 1801
8
Sarah Stone
[1.3.2.1.4.6.13.4]
b. 21 Apr 1805 d. 1849
Lucius Augustus Bingham
b. 1 Sep 1804
9
Calvin Bingham
[1.3.2.1.4.6.13.4.1]
b. 7 Sep 1827 d. 27 May 1883
9
Benjamin Bingham
[1.3.2.1.4.6.13.4.2]
b. 1829 d. 27 May 1883
9
Augustus Bingham
[1.3.2.1.4.6.13.4.3]
b. 27 Oct 1831 d. 20 May 1908
9
Levi Perry Bingham
[1.3.2.1.4.6.13.4.4]
b. 5 Nov 1832 d. 9 Oct 1903
Sarah Ann Elizabeth Lusk
b. 21 Nov 1833 d. 28 Apr 1893
10
Louisa Elizabeth Bingham
[1.3.2.1.4.6.13.4.4.1]
b. 22 Jun 1853 d. 7 Feb 1935
10
Susan Emaline Bingham
[1.3.2.1.4.6.13.4.4.2]
b. 16 Jun 1855 d. 26 Mar 1935
10
Perry Calvin Bingham
[1.3.2.1.4.6.13.4.4.3]
b. 29 Jun 1857 d. 17 Jul 1916
Rachel Elvira Henderson
b. 25 Jan 1858 d. 10 Dec 1907
11
Sarah Elvira Bingham
[1.3.2.1.4.6.13.4.4.3.1]
b. 10 Dec 1876 d. 11 Jan 1880
11
Louisa Emaline Bingham
[1.3.2.1.4.6.13.4.4.3.2]
b. 1 Jan 1879 d. 27 Jul 1959
Samuel Marion Lee Jr
b. 22 Nov 1875 d. 9 May 1947
12
Samuel Perry Lee
[1.3.2.1.4.6.13.4.4.3.2.1]
b. 5 Dec 1896 d. 14 Aug 1978
12
Harold Bingham Lee
[1.3.2.1.4.6.13.4.4.3.2.2]
b. 28 Mar 1899 d. 26 Dec 1973 [
=>
]
12
Clyde Bingham Lee
[1.3.2.1.4.6.13.4.4.3.2.3]
b. 12 Oct 1902 d. 11 Sep 1953
12
Waldo Bingham Lee
[1.3.2.1.4.6.13.4.4.3.2.4]
b. 24 Nov 1905 d. 14 Feb 1959
12
Stella Bingham Lee
[1.3.2.1.4.6.13.4.4.3.2.5]
b. 23 Dec 1907 d. 28 Jan 1974
12
Verda Bingham Lee
[1.3.2.1.4.6.13.4.4.3.2.6]
b. 1 Jul 1910 d. 26 Aug 1991
11
Perry Calvin Bingham
[1.3.2.1.4.6.13.4.4.3.3]
b. 4 Jan 1882 d. 10 Dec 1894
11
Effie Lucretia Bingham
[1.3.2.1.4.6.13.4.4.3.4]
b. 28 Dec 1884 d. 21 Oct 1946
11
Mary F Bingham
[1.3.2.1.4.6.13.4.4.3.5]
b. 29 Dec 1887 bur. Feb 1888
11
Dora Bingham
[1.3.2.1.4.6.13.4.4.3.6]
b. 29 Nov 1890
11
Zeida Bingham
[1.3.2.1.4.6.13.4.4.3.7]
b. 1 Jun 1895
10
John Samuel Bingham
[1.3.2.1.4.6.13.4.4.4]
b. 23 Feb 1860 d. 6 Sep 1927
10
Lucius Augustus Bingham
[1.3.2.1.4.6.13.4.4.5]
b. 5 Apr 1862 d. 16 Jan 1931
10
Lucy Lucretia Bingham
[1.3.2.1.4.6.13.4.4.6]
b. 28 Jun 1864 d. 2 Jul 1917
10
Sarah Maria Bingham
[1.3.2.1.4.6.13.4.4.7]
b. 8 Apr 1867 d. 16 Apr 1936
10
William David Bingham
[1.3.2.1.4.6.13.4.4.8]
b. 8 Jun 1870 d. 6 Sep 1899
10
Mary Ardella Bingham
[1.3.2.1.4.6.13.4.4.9]
b. 21 Sep 1874 d. 7 Dec 1915
9
Son Bingham
[1.3.2.1.4.6.13.4.5]
b. 10 May 1834 d. Abt 1835
9
Mary Emiline Bingham
[1.3.2.1.4.6.13.4.6]
b. 10 May 1834 d. 1874
9
Prosper Bingham
[1.3.2.1.4.6.13.4.7]
b. 1840 d. Abt 1845
9
Lucy Bingham
[1.3.2.1.4.6.13.4.8]
b. 1843
6
Ann Nutting
[1.3.2.1.4.7]
b. 22 May 1730 d. 24 Sep 1778
5
Daniel Nutting
[1.3.2.1.5]
b. Abt 1691 d. Abt 7 Aug 1756
5
Eleazer Nutting
[1.3.2.1.6]
b. Abt 1698 d. 10 Mar 1791
4
James Nutting
[1.3.2.2]
b. 28 Jun 1653 d. 15 May 1732
4
Mary Nutting
[1.3.2.3]
b. 10 Jan 1655 d. 1 Sep 1727
4
Josiah Nutting
[1.3.2.4]
b. 10 Jun 1657 d. 10 Dec 1658
4
Sarah Nutting
[1.3.2.5]
b. 7 Jan 1659 d. 1659
3
Ruth Eggleston
[1.3.3]
b. 1631 d. 14 Oct 1703
3
Elizabeth Eggleston
[1.3.4]
b. 9 Oct 1636 d. 20 Oct 1646
2
William Bennett
[1.4]
c. 21 Mar 1606
+
Dorothy Scott
b. 1611 d. 1680
2
Governor Richard Bennett
[1.5]
c. 6 Aug 1609 d. 12 Apr 1675
Mary Ann Longsworth
b. 1619 d. 1687
3
Elizabeth Bennett
[1.5.1]
b. 1642 d. 4 Aug 1719
Charles Scarborough
b. 1643 d. 6 Oct 1702
4
Bennett Scarborough
[1.5.1.1]
b. Abt 1673 bur. Abt 7 May 1734
4
Charles Scarborough
[1.5.1.2]
b. 1677 d. 5 Jan 1724/1725
4
Henry Scarborough
[1.5.1.3]
b. Abt 1679 bur. 4 Nov 1735
4
Tabitha Scarborough
[1.5.1.4]
b. 1680 bur. 1 Nov 1748
4
Mary Scarborough
[1.5.1.5]
b. Abt 1681 d. Aft 1721
4
Sarah Scarborough
[1.5.1.6]
b. 1683 d. 1728
3
Richard Bennett
[1.5.2]
b. 1643 d. 6 May 1667
3
Anna Bennett
[1.5.3]
d. Nov 1687
2
Philip Bennett
[1.6]
c. 22 May 1611
2
Johane Bennett
[1.7]
c. 7 Jul 1614 bur. 21 Aug 1616