Home Page
|
What's New
|
Photos
|
Histories
|
Headstones
|
Reports
|
Surnames
Search
First Name:
Last Name:
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Suomalainen
Svenska
John Riddlesdale
1557 - 1629 (71 years)
Submit Photo / Document
Individual
Descendants
Relationship
Timeline
Submit Photo / Doc
Worksheet
Family
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
John Riddlesdale
[1]
b. 26 Sep 1557 d. 4 Jun 1629
Dorcas Black
b. 1560 d. 24 Sep 1624
2
Susannah Riddlesdale
[1.1]
b. 1584 d. Aug 1658
Thomas French
b. 11 Oct 1584 d. 5 Nov 1639
3
Ensign Thomas French, Jr
[1.1.1]
b. 27 Nov 1608 d. 8 Aug 1680
Mary Scudamore
b. 1612 d. 6 May 1681
4
Mary French
[1.1.1.1]
b. 23 Sep 1632 d. 22 Mar 1683
Robert Smith, Jr
b. Jan 1625 d. 30 Aug 1693
5
Thomas Smith
[1.1.1.1.1]
b. 7 Jul 1654 d. 25 Feb 1725
Martha Knowlton
b. 1654 d. 4 Dec 1728
6
Thomas Smith
[1.1.1.1.1.1]
b. 4 Apr 1683 d. 29 Aug 1729
6
Sarah Smith
[1.1.1.1.1.2]
b. Dec 1685 d. 19 Aug 1704
6
Martha Smith
[1.1.1.1.1.3]
b. Abt 1688 d. Dec 1748
6
John Smith
[1.1.1.1.1.4]
b. 24 Jan 1688 d. 22 Nov 1735
Elizabeth Burnham
7
John Smith
[1.1.1.1.1.4.1]
b. 31 Jul 1715 d. 6 Apr 1714
Eleanor Jewett Smith
b. Abt 1717
8
Samuel Smith
[1.1.1.1.1.4.1.1]
b. Abt 1736 d. Abt 1799
8
Mary Smith
[1.1.1.1.1.4.1.2]
b. 22 Jan 1738 d. 26 Sep 1806
8
Thomas Smith
[1.1.1.1.1.4.1.3]
b. 12 Oct 1741 d. 25 Apr 1794
Phoebe Richardson
b. 5 Dec 1740 d. 19 May 1829
9
Thomas Smith
[1.1.1.1.1.4.1.3.1]
b. 10 Nov 1765 d. 17 May 1837
9
Sylvanus Smith
[1.1.1.1.1.4.1.3.2]
b. 1 Jul 1767 d. 22 Feb 1842
Cylinda Hurd
b. Abt 1769 d. Feb 1842
10
Alvin Smith
[1.1.1.1.1.4.1.3.2.1]
b. 10 Apr 1795
10
Elijah Smith
[1.1.1.1.1.4.1.3.2.2]
b. 5 Dec 1796 d. 11 May 1836
10
Vesta Olive Smith
[1.1.1.1.1.4.1.3.2.3]
b. 1798 d. 6 Jul 1878
10
Electa Smith
[1.1.1.1.1.4.1.3.2.4]
b. 5 Apr 1801 d. 21 Jan 1837
10
Lydia Smith
[1.1.1.1.1.4.1.3.2.5]
b. Abt 1802 d. 28 Apr 1883
10
Eunice Smith
[1.1.1.1.1.4.1.3.2.6]
b. 20 May 1806 d. 22 Apr 1894
10
Emeline Smith
[1.1.1.1.1.4.1.3.2.7]
b. Abt 1809 d. 25 Feb 1847
10
Celesta Caroline Smith
[1.1.1.1.1.4.1.3.2.8]
b. 26 Feb 1811 d. 9 Mar 1885
10
Addison Smith
[1.1.1.1.1.4.1.3.2.9]
b. 5 Aug 1814 d. 31 Jan 1879
10
Moses Smith
[1.1.1.1.1.4.1.3.2.10]
b. 1816
9
Electa Smith
[1.1.1.1.1.4.1.3.3]
b. 15 Mar 1769 d. 30 Mar 1813
8
Aaron Smith
[1.1.1.1.1.4.1.4]
b. Abt 1747
8
Sarah Smith
[1.1.1.1.1.4.1.5]
b. Abt 1749
8
Elisha Smith
[1.1.1.1.1.4.1.6]
b. Abt 1758 d. Aft Nov 1808
7
Benjamin Smith
[1.1.1.1.1.4.2]
b. 5 Mar 1717
7
Susanna Smith
[1.1.1.1.1.4.3]
b. 23 Oct 1722
7
Ruth Smith
[1.1.1.1.1.4.4]
c. 11 Jul 1725 d. 28 Jul 1811
7
Abigail Smith
[1.1.1.1.1.4.5]
b. 28 Mar 1725 d. 21 Jun 1725
7
Ephraim Smith
[1.1.1.1.1.4.6]
b. 28 Mar 1727 d. 15 Jun 1727
7
Esther Smith
[1.1.1.1.1.4.7]
b. 9 Feb 1728
6
Ebenezer Smith
[1.1.1.1.1.5]
b. 31 Jul 1690 d. 25 Feb 1758
6
Ephraim Smith
[1.1.1.1.1.6]
b. 12 Aug 1692 d. 3 Sep 1720
6
Mary Smith
[1.1.1.1.1.7]
b. 10 Sep 1694 d. 25 Aug 1785
6
Abigail Smith
[1.1.1.1.1.8]
b. 1696 d. 1 Feb 1772
5
Mary Smith
[1.1.1.1.2]
b. 20 Oct 1658 d. 10 Dec 1716
John Towne
b. 2 Apr 1658 d. 27 Nov 1740
6
John Towne, Jr
[1.1.1.1.2.1]
b. 25 Nov 1682 d. 29 Sep 1683
6
Israel Towne
[1.1.1.1.2.2]
b. 18 Nov 1684 d. 29 Oct 1771
6
Esther Towne
[1.1.1.1.2.3]
b. 13 Dec 1686 d. Bef Oct 1744
6
Ephraim Towne
[1.1.1.1.2.4]
b. 22 Apr 1688 d. 1779
6
David Towne
[1.1.1.1.2.5]
b. 22 Oct 1693 d. 20 Sep 1781
6
Samuel Towne
[1.1.1.1.2.6]
b. 25 Jan 1695 d. 27 Nov 1760
6
Edmund Towne
[1.1.1.1.2.7]
b. 7 May 1699 d. 27 May 1745
Elizabeth Gould
b. 3 Feb 1703 d. 17 Sep 1742
7
Eliza Goold
[1.1.1.1.2.7.1]
b. 29 Dec 1723
7
Debora Goold
[1.1.1.1.2.7.2]
b. Abt 1724 d. 12 Mar 1812
7
Mehitabel Goold
[1.1.1.1.2.7.3]
b. 10 Nov 1728
7
Edmund Towne
[1.1.1.1.2.7.4]
b. 10 Sep 1733
7
Nathaniel Gould
[1.1.1.1.2.7.5]
b. 17 Nov 1734 d. Dec 1781
7
Zaccheus Town
[1.1.1.1.2.7.6]
b. 20 Feb 1736 d. 1740
7
Bathsheba Towne
[1.1.1.1.2.7.7]
b. 28 Mar 1740 d. 1741
7
Mary Towne
[1.1.1.1.2.7.8]
b. 7 Sep 1742 d. 1742
6
John Town, Jr
[1.1.1.1.2.8]
b. 31 May 1702 d. 1775
5
Phebe Smith
[1.1.1.1.3]
b. 26 Aug 1661 d. 14 Jan 1740
Jacob Towne
b. 13 Feb 1658 d. 1 Oct 1741
6
Joshua Towne
[1.1.1.1.3.1]
b. 13 Nov 1684 d. 11 Jun 1762
6
Abigail Towne
[1.1.1.1.3.2]
b. 2 Oct 1687
6
Catharine Towne
[1.1.1.1.3.3]
b. 2 Jan 1690 d. Abt 1720
6
Jacob Towne
[1.1.1.1.3.4]
b. 1693 d. 27 Sep 1727
6
Ruth Towne
[1.1.1.1.3.5]
b. 25 Mar 1698 d. 1 Aug 1739
6
Stephen Towne
[1.1.1.1.3.6]
b. 2 Nov 1700 d. Abt 1777
6
Jabez Towne
[1.1.1.1.3.7]
b. 15 Jun 1704 d. 1 Apr 1783
6
Elisha Towne
[1.1.1.1.3.8]
b. 25 Oct 1706 d. 1786
Sarah Elizabeth Rhodes
b. 6 May 1712 d. 16 May 1762
7
Sarah Towne
[1.1.1.1.3.8.1]
b. 7 Jan 1738
7
John Sergeant Towne
[1.1.1.1.3.8.2]
b. 22 Sep 1740 d. 8 Mar 1830
Anna Cummings
b. 29 May 1745 d. 1816
8
Asa Towne
[1.1.1.1.3.8.2.1]
b. 14 Nov 1764
8
Sarah Towne
[1.1.1.1.3.8.2.2]
b. 12 Mar 1766
8
Anna Towne
[1.1.1.1.3.8.2.3]
b. 2 Sep 1767 d. 24 Mar 1851
8
Amos Towne
[1.1.1.1.3.8.2.4]
b. 17 Apr 1769 d. 1 Mar 1857
8
John Towne
[1.1.1.1.3.8.2.5]
b. 27 Aug 1771 d. 26 Jan 1830
8
Solomon Towne
[1.1.1.1.3.8.2.6]
b. 10 May 1774 d. 5 Jun 1835
8
Joseph Towne
[1.1.1.1.3.8.2.7]
b. 22 Oct 1777
8
Daniel Towne
[1.1.1.1.3.8.2.8]
b. 30 Sep 1779
8
Samuel Towne
[1.1.1.1.3.8.2.9]
b. 27 Mar 1783 d. 24 Oct 1858
8
Lucy Towne
[1.1.1.1.3.8.2.10]
b. 3 Oct 1785 d. 29 Apr 1820
8
Oliver Towne
[1.1.1.1.3.8.2.11]
b. 24 May 1789
7
Mehetabel Town
[1.1.1.1.3.8.3]
b. 23 Sep 1742
7
Absalom Towne
[1.1.1.1.3.8.4]
b. 24 Sep 1744 d. 14 Nov 1813
7
Bathsheba Towne
[1.1.1.1.3.8.5]
b. 18 Oct 1747 d. 25 Jul 1830
5
Ephraim Smith
[1.1.1.1.4]
b. 29 Oct 1663 d. Abt 1732
Mary Ramsdell
b. 27 Jan 1674
6
Mary Smith
[1.1.1.1.4.1]
b. Aug 1695
6
Elizabeth Smith
[1.1.1.1.4.2]
b. 1 Mar 1696
6
Hannah Smith
[1.1.1.1.4.3]
b. 1 Mar 1696
6
Lydia Smith
[1.1.1.1.4.4]
b. Abt 1699 d. 1747
6
Hephzeba Smith
[1.1.1.1.4.5]
b. 25 Mar 1700
6
John Smith
[1.1.1.1.4.6]
b. 18 Nov 1701 d. 26 May 1729
6
Pricilla Smith
[1.1.1.1.4.7]
b. 14 Aug 1702 d. 2 Jan 1738
6
Ephraim Smith
[1.1.1.1.4.8]
b. Abt 1710
6
Nathan Smith
[1.1.1.1.4.9]
b. 1 Jul 1710 d. Abt 1800
6
Abijah Smith
[1.1.1.1.4.10]
c. 17 Oct 1714 d. 10 Jan 1785
6
Sarah Smith
[1.1.1.1.4.11]
b. 20 Nov 1716
Nathaniel Spofford
b. 1712
7
Apphia Spofford
[1.1.1.1.4.11.1]
b. 12 Jan 1734
7
Jonathan Spofford
[1.1.1.1.4.11.2]
b. 28 May 1740
7
Jerusha Spofford
[1.1.1.1.4.11.3]
b. 17 May 1742 d. 26 Nov 1812
7
Jacob Spofford
[1.1.1.1.4.11.4]
b. 24 Jan 1744
7
Nathanael Spofford
[1.1.1.1.4.11.5]
b. Abt 1747
5
Samuel Smith
[1.1.1.1.5]
b. 26 Jan 1666 d. 12 Jul 1748
Rebecca Curtis
b. 20 Jan 1687 d. 2 Mar 1753
6
Phebe Smith
[1.1.1.1.5.1]
b. 8 Jan 1708 d. 2 Mar 1753
Stephen Averill
b. 1704 d. 1753
7
Phebe Averell
[1.1.1.1.5.1.1]
b. Abt 1734
7
Rebecca Averell
[1.1.1.1.5.1.2]
b. Abt 1736
7
Sarah Averell
[1.1.1.1.5.1.3]
b. Abt 1738
7
Samuel Averell
[1.1.1.1.5.1.4]
b. Abt 1740
6
Mary Smith
[1.1.1.1.5.2]
b. 14 Aug 1711 d. 14 Nov 1785
Amos Towne
b. 2 Jul 1709 d. 14 Feb 1747
7
Samuel Towne
[1.1.1.1.5.2.1]
b. Abt 1735
7
Amos Towne
[1.1.1.1.5.2.2]
b. Oct 1737 d. 8 Sep 1793
7
Daniel Towne
[1.1.1.1.5.2.3]
b. 28 Oct 1739
6
Captain Samuel T Smith
[1.1.1.1.5.3]
b. 26 Jan 1714 d. 14 Nov 1785
Priscilla Gould
b. 4 Aug 1707 d. 25 Sep 1744
7
Priscilla Smith
[1.1.1.1.5.3.1]
b. 26 Dec 1735 d. 7 Dec 1792
Jacob Kimball
b. 5 Mar 1731 d. 8 Nov 1810
8
Benjamin Kimball
[1.1.1.1.5.3.1.1]
b. 23 Jan 1757 d. 19 Aug 1776
8
Mehetiball Kimbal
[1.1.1.1.5.3.1.2]
b. 3 Dec 1758 d. 12 Nov 1790
8
Jacob Kimball
[1.1.1.1.5.3.1.3]
b. 2 Feb 1761 d. 24 Jul 1826
8
Priscilla Kimball
[1.1.1.1.5.3.1.4]
b. 10 Mar 1763 d. 2 Sep 1792
8
Ann Kimball
[1.1.1.1.5.3.1.5]
b. 2 Jun 1765 d. 12 Sep 1789
8
Lucy Kimball
[1.1.1.1.5.3.1.6]
b. 6 Sep 1767 bur. Sep 1790
8
Lydia Kimball
[1.1.1.1.5.3.1.7]
b. 28 Jan 1770 d. 20 Apr 1795
8
David Kimball
[1.1.1.1.5.3.1.8]
b. 26 Apr 1772 d. 20 Nov 1795
8
Samuel Kimball
[1.1.1.1.5.3.1.9]
b. Dec 1774 d. 10 Sep 1775
7
Samuel Smith, III
[1.1.1.1.5.3.2]
b. 28 Oct 1737 d. 14 Nov 1785
Rebecca Lovett
b. 9 Jun 1737 d. Aft 1760
8
Rebekah Smith
[1.1.1.1.5.3.2.1]
b. 29 Jun 1760 d. 15 Apr 1816
8
Lydia Smith
[1.1.1.1.5.3.2.2]
b. 14 Apr 1762 d. 19 Dec 1850
Jacob Wilds
b. Abt 1780 d. 16 Jan 1841
9
Mary Wilds
[1.1.1.1.5.3.2.2.1]
b. Sep 1787 d. 29 Feb 1856
9
Moses Wilds
[1.1.1.1.5.3.2.2.2]
b. 8 Oct 1790 d. 1 Nov 1879
Abigail King
b. 10 Jun 1800 d. 25 Aug 1887
10
Mary Wilds
[1.1.1.1.5.3.2.2.2.1]
b. 14 Feb 1818 d. 21 Apr 1895
Nathan A Smith
b. 12 Feb 1820 d. 11 Apr 1888
11
Lydia Smith
[1.1.1.1.5.3.2.2.2.1.1]
b. 4 Aug 1847 d. 22 Nov 1937
+
George B Holbrook
b. 24 Jun 1855 d. 6 May 1926
11
Carlos William Smith
[1.1.1.1.5.3.2.2.2.1.2]
b. 18 Aug 1852 d. 2 May 1928
+
Sarah Clark
b. Abt 1863 d. 1885/1895
Mertie May Smith Loomis
b. 11 Apr 1861 d. 11 Sep 1925
12
Flora Winifred Smith
[1.1.1.1.5.3.2.2.2.1.2.1]
b. 16 Jan 1897 d. 7 Jul 1966 [
=>
]
12
Monroe William Smith
[1.1.1.1.5.3.2.2.2.1.2.2]
b. 22 Jan 1901 d. 8 Dec 1972 [
=>
]
10
Lydia Wilds
[1.1.1.1.5.3.2.2.2.2]
b. 4 Feb 1820
Thomas Jefferson Dickey
b. 10 Dec 1808 d. 1 Feb 1881
11
Henry Dickey
[1.1.1.1.5.3.2.2.2.2.1]
b. 1842 d. 1913
11
Clara Ellen Dickey
[1.1.1.1.5.3.2.2.2.2.2]
b. 5 Apr 1849 d. 15 Jun 1877
John Sawyer
b. Jul 1836 d. 20 Jul 1913
12
Son Sawyer
[1.1.1.1.5.3.2.2.2.2.2.1]
b. 30 Sep 1867
12
Carrie Ella Sawyer
[1.1.1.1.5.3.2.2.2.2.2.2]
b. 6 Jan 1871 d. 21 Nov 1961
12
Daughter Sawyer
[1.1.1.1.5.3.2.2.2.2.2.3]
b. 25 Jan 1876 d. 24 Mar 1876
11
Thomas Jefferson Dickey, Jr
[1.1.1.1.5.3.2.2.2.2.3]
b. 26 Jan 1850 d. 26 Mar 1865
11
Rose A Dickey
[1.1.1.1.5.3.2.2.2.2.4]
b. 22 Jan 1854 d. 22 Mar 1874
11
Lillian Dickey
[1.1.1.1.5.3.2.2.2.2.5]
b. 29 Sep 1859
10
Mehitable "Hittie" Wilds
[1.1.1.1.5.3.2.2.2.3]
b. 17 Jun 1826 d. 1 Nov 1910
Richard Peckham Church
b. 27 Nov 1819 d. 27 Nov 1897
11
George King Church
[1.1.1.1.5.3.2.2.2.3.1]
b. 1 May 1844 d. 1937
Lydia R Cilley
b. 22 Jul 1842 d. 12 Oct 1908
12
Martha L Church
[1.1.1.1.5.3.2.2.2.3.1.1]
b. 1 Sep 1866
12
Lena May Church
[1.1.1.1.5.3.2.2.2.3.1.2]
b. 7 Nov 1877
11
Lydia Church
[1.1.1.1.5.3.2.2.2.3.2]
b. 1846
11
Flora Church
[1.1.1.1.5.3.2.2.2.3.3]
b. Abt 30 Apr 1856 d. 31 Aug 1859
11
Floran A Church
[1.1.1.1.5.3.2.2.2.3.4]
b. 15 May 1859 d. 14 Dec 1931
Hannah E Smith
b. Mar 1863
12
Hilas Bathelder Church
[1.1.1.1.5.3.2.2.2.3.4.1]
b. 9 Sep 1882
12
Etta Bell Church
[1.1.1.1.5.3.2.2.2.3.4.2]
b. 23 Apr 1886
12
George Elwood Church
[1.1.1.1.5.3.2.2.2.3.4.3]
b. Abt 5 Jun 1888 d. 10 Jul 1889
12
Kenneth Clyde Church
[1.1.1.1.5.3.2.2.2.3.4.4]
b. 9 Jun 1890
10
Sally J Wilds
[1.1.1.1.5.3.2.2.2.4]
b. Abt 1828
Christopher Columbus Payne
b. 28 Sep 1828 d. 1 Dec 1883
11
Wilson A Payne
[1.1.1.1.5.3.2.2.2.4.1]
b. 1851 d. 1926
+
Rhoda E Daya
b. 1847
11
Abbie S Payne
[1.1.1.1.5.3.2.2.2.4.2]
b. 1854
John Flanders
12
John Flanders
[1.1.1.1.5.3.2.2.2.4.2.1]
b. 1878 d. 25 Dec 1949
11
Dwight C Payne
[1.1.1.1.5.3.2.2.2.4.3]
b. May 1868 d. 4 Apr 1870
10
Cynthia C Wilds
[1.1.1.1.5.3.2.2.2.5]
b. 30 Aug 1831 d. 26 May 1930
+
Samuel G Saville
b. 28 Nov 1828 d. 1 Dec 1918
9
Asa Wilds
[1.1.1.1.5.3.2.2.3]
b. Abt 1795 d. Abt 1831
9
Nancy Wilds
[1.1.1.1.5.3.2.2.4]
b. 12 May 1798 d. 4 Dec 1884
9
William Wilds
[1.1.1.1.5.3.2.2.5]
b. 16 Jan 1800 d. 16 Feb 1876
Sarah King
b. 19 Jan 1804 d. 13 Mar 1866
10
Diantha Wilds
[1.1.1.1.5.3.2.2.5.1]
b. 2 Dec 1831
Aaron Bunnell Sargent
b. 7 Jun 1829
11
Mary S Sargent
[1.1.1.1.5.3.2.2.5.1.1]
b. 24 Jun 1852 d. 19 Apr 1902
Azariah Barnes
b. Nov 1841 d. Aft 1880
12
Ethel Rosamond Barnes
[1.1.1.1.5.3.2.2.5.1.1.1]
b. 4 Aug 1873 d. 6 Jun 1947 [
=>
]
12
Katie Alice Barnes
[1.1.1.1.5.3.2.2.5.1.1.2]
b. 12 Sep 1875
12
Wilford A Barnes
[1.1.1.1.5.3.2.2.5.1.1.3]
b. 1881 d. 11 Nov 1900
12
Minnie May Barnes
[1.1.1.1.5.3.2.2.5.1.1.4]
b. 9 Jan 1886 d. 9 Oct 1965 [
=>
]
12
Vernie Mildred Barnes
[1.1.1.1.5.3.2.2.5.1.1.5]
b. 16 Oct 1892
12
Nellie D Barnes
[1.1.1.1.5.3.2.2.5.1.1.6]
b. 28 Oct 1878 d. 26 May 1941 [
=>
]
10
Diana Wilds
[1.1.1.1.5.3.2.2.5.2]
b. 2 Dec 1831
Almon Richardson Thurston
b. Abt 1829
11
Emma Thurston
[1.1.1.1.5.3.2.2.5.2.1]
b. 1858
11
Claira C. Thurston
[1.1.1.1.5.3.2.2.5.2.2]
b. 28 Jun 1859
10
Merrill F Wilds
[1.1.1.1.5.3.2.2.5.3]
b. 23 Dec 1832 d. 27 Jul 1903
Satira Bradford
b. Abt 10 Apr 1842 d. 20 Oct 1897
11
Etta May Wilds
[1.1.1.1.5.3.2.2.5.3.1]
b. 21 Jun 1866 d. 22 Dec 1933
Charles Colburn Lord
b. 29 Aug 1864 d. 20 Dec 1944
12
Ralph Christie Lord
[1.1.1.1.5.3.2.2.5.3.1.1]
b. 19 May 1890 d. 5 Feb 1969
12
Wendell E Lord
[1.1.1.1.5.3.2.2.5.3.1.2]
b. 19 Aug 1894 d. 8 Nov 1918
12
Merle E Lord
[1.1.1.1.5.3.2.2.5.3.1.3]
b. 12 Apr 1900 d. 29 Apr 1900
12
Charles Delwin Lord
[1.1.1.1.5.3.2.2.5.3.1.4]
b. 6 Aug 1902 d. 13 Nov 1997
12
Alice Etta Lord
[1.1.1.1.5.3.2.2.5.3.1.5]
b. 19 Jan 1905 d. 12 May 1998
11
Rosie Emma Wilds
[1.1.1.1.5.3.2.2.5.3.2]
b. 21 Apr 1870 d. 27 Dec 1903
Edward D Cook
b. 1865 d. 1935
12
Nellie Cook
[1.1.1.1.5.3.2.2.5.3.2.1]
b. 14 Sep 1897 d. Jun 1983
12
Helen Almina Cook
[1.1.1.1.5.3.2.2.5.3.2.2]
b. 30 Oct 1903 d. 18 May 1931
10
Sarah King Wilds
[1.1.1.1.5.3.2.2.5.4]
b. 2 May 1834 d. 29 Jan 1906
Charles Poole
b. Abt 1830 d. 27 Jan 1906
11
Edward C Poole
[1.1.1.1.5.3.2.2.5.4.1]
b. 1 Nov 1854
11
Ada M Poole
[1.1.1.1.5.3.2.2.5.4.2]
b. 9 Nov 1856 d. 18 Jul 1890
+
Martin luther Sanborn
b. 1852
11
Gertrude S Poole
[1.1.1.1.5.3.2.2.5.4.3]
b. 21 Jun 1863
Walter P Bugbee
b. Abt 1860
12
Orpha P Bugbee
[1.1.1.1.5.3.2.2.5.4.3.1]
b. 22 Apr 1884
12
Charles L Bugbee
[1.1.1.1.5.3.2.2.5.4.3.2]
b. 27 Jun 1886
11
William Everett Poole
[1.1.1.1.5.3.2.2.5.4.4]
b. 13 Jun 1867
+
Hattie L Miller
b. 1871
10
Louisa Wilds
[1.1.1.1.5.3.2.2.5.5]
b. 13 Dec 1838 d. 26 Dec 1893
Alexander Franklin Hayward
b. 11 Apr 1836 d. 4 Jul 1911
11
Ernest Franklin Hayward
[1.1.1.1.5.3.2.2.5.5.1]
b. 1 Oct 1874 d. 17 May 1951
Jennie May Taplin
b. 27 May 1887 d. 6 Feb 1972
12
Vernon Edward Hayward
[1.1.1.1.5.3.2.2.5.5.1.1]
b. 26 Jan 1908 d. 20 Oct 1978
12
Merlin Franklin Hayward
[1.1.1.1.5.3.2.2.5.5.1.2]
b. 17 Mar 1909 d. 3 Dec 1974 [
=>
]
10
Almira Elizabeth Wilds
[1.1.1.1.5.3.2.2.5.6]
b. 11 Sep 1840 d. 21 Feb 1906
Charles Howard Beede
b. 3 Aug 1839 d. 4 Apr 1911
11
Clinton Horatio Beede
[1.1.1.1.5.3.2.2.5.6.1]
b. 11 Jan 1865 d. 19 Mar 1942
+
Besse Viola Jefferds
b. 24 Sep 1880 d. 30 Jan 1964
Ethel Winifred Ladd
b. 6 Sep 1877 d. 7 May 1920
12
Kenneth Charles Beede
[1.1.1.1.5.3.2.2.5.6.1.1]
b. 22 Nov 1898 d. 5 Mar 1961
12
Inez Winifred Beede
[1.1.1.1.5.3.2.2.5.6.1.2]
b. 7 Feb 1900 d. 29 Dec 1978
12
Velma Ladd Beede
[1.1.1.1.5.3.2.2.5.6.1.3]
b. 30 Jan 1903 d. 1984
11
Caroline Adell Beede
[1.1.1.1.5.3.2.2.5.6.2]
b. 28 Apr 1868 d. 12 Sep 1934
Charles N Wales
b. 1864
12
Almira Wales
[1.1.1.1.5.3.2.2.5.6.2.1]
b. Abt 1890
12
Eva May Wales
[1.1.1.1.5.3.2.2.5.6.2.2]
b. Nov 1891
+
Lester Sanborn
b. Abt 1864
11
Rose Emma Beede
[1.1.1.1.5.3.2.2.5.6.3]
b. 1 Nov 1871 d. 17 Nov 1919
Frank Matthew Allen
b. 1865 d. 17 Nov 1919
12
Florence Allen
[1.1.1.1.5.3.2.2.5.6.3.1]
b. 20 Jun 1893
12
Russell Allen
[1.1.1.1.5.3.2.2.5.6.3.2]
b. 5 Jan 1897
12
Sheldon Chancey Allen
[1.1.1.1.5.3.2.2.5.6.3.3]
b. 23 Dec 1900 d. 4 Jan 1996
11
Bertha Alice Beede
[1.1.1.1.5.3.2.2.5.6.4]
b. 22 Oct 1877 d. 27 May 1932
Chauncy Elmer Bixby
b. 14 Sep 1874
12
Velma Christina Bixby
[1.1.1.1.5.3.2.2.5.6.4.1]
b. 25 Mar 1904 d. 1997
11
Ada May Beede
[1.1.1.1.5.3.2.2.5.6.5]
b. 26 May 1881 d. 13 Aug 1881
10
John K Wilds
[1.1.1.1.5.3.2.2.5.7]
d. 5 Feb 1909
Eunice M Dexter
b. 17 Feb 1831 d. 29 May 1898
11
Elwin Aaron Wilds
[1.1.1.1.5.3.2.2.5.7.1]
b. 9 Dec 1859 d. 2 Jul 1932
Mary Tabitha Courtney
b. 26 Nov 1870 d. 13 Jul 1901
12
Pearl Elisabeth Wilds
[1.1.1.1.5.3.2.2.5.7.1.1]
b. 13 May 1884 d. 16 Feb 1973 [
=>
]
12
Roy Elwin Wilds
[1.1.1.1.5.3.2.2.5.7.1.2]
b. 11 Apr 1892 d. 18 Aug 1975 [
=>
]
12
Ralph Oscar Wilds
[1.1.1.1.5.3.2.2.5.7.1.3]
b. 15 Feb 1898 d. Aft 1984
+
Willie Ann Cline
b. 18 Feb 1863 d. 12 Jan 1931
+
Alice Curtis
b. Abt 1850
9
Susan Wilds
[1.1.1.1.5.3.2.2.6]
b. 16 Mar 1803 d. 18 Jan 1869
8
Susanna Smith
[1.1.1.1.5.3.2.3]
b. 9 Mar 1764 d. 18 Sep 1781
8
Samuel Smith
[1.1.1.1.5.3.2.4]
b. 1 Apr 1766 d. 21 Mar 1811
8
Elizabeth Mary Smith
[1.1.1.1.5.3.2.5]
b. 31 Mar 1768
8
Jacob Smith
[1.1.1.1.5.3.2.6]
b. 24 May 1770
8
Anna Smith
[1.1.1.1.5.3.2.7]
b. 8 Jan 1772
8
Son Smith
[1.1.1.1.5.3.2.8]
b. 13 Apr 1773
8
Benjamin Smith
[1.1.1.1.5.3.2.9]
b. 20 Feb 1776 d. 2 Oct 1778
7
Vashti Smith
[1.1.1.1.5.3.3]
b. 5 Oct 1739 d. Aft 1776
Jacobs Hobbs
b. 16 Jun 1745 d. 20 Jan 1823
8
Jacob Hobbs
[1.1.1.1.5.3.3.1]
b. 21 Feb 1768
8
Abraham Hobbs
[1.1.1.1.5.3.3.2]
b. 16 Dec 1769
8
Samuel Hobbs
[1.1.1.1.5.3.3.3]
b. 21 Feb 1772
8
Vashti Hobbs
[1.1.1.1.5.3.3.4]
b. 2 Feb 1774 d. 14 Feb 1836
8
Abigail Hobbs
[1.1.1.1.5.3.3.5]
b. 10 Aug 1776
Soloman Curtis
b. 10 Jul 1739 d. Apr 1766
8
Solomon Curtis
[1.1.1.1.5.3.3.6]
b. 13 Apr 1766
7
Susannah Smith
[1.1.1.1.5.3.4]
b. 24 Jan 1741 d. 13 May 1766
Isaac Hobbs
b. 20 Apr 1743 d. 3 Jun 1815
8
Sarah Hobbs
[1.1.1.1.5.3.4.1]
b. 16 Nov 1766 d. 27 Jan 1823
8
Susannah Hobbs
[1.1.1.1.5.3.4.2]
b. 16 Nov 1766 d. Abt 1870
8
Priscilla Hobbs
[1.1.1.1.5.3.4.3]
b. 28 May 1769 d. 18 May 1771
8
Isaac Hobbs
[1.1.1.1.5.3.4.4]
b. 19 Aug 1770 d. Abt 1870
8
Elizabeth Hobbs
[1.1.1.1.5.3.4.5]
b. 16 Jan 1773 d. 14 Nov 1850
8
Munson Hobbs
[1.1.1.1.5.3.4.6]
b. 5 Mar 1775 d. Abt 1870
8
Samuel Hobbs
[1.1.1.1.5.3.4.7]
b. 1 Dec 1776 d. Abt 1870
8
Humphrey Hobbs
[1.1.1.1.5.3.4.8]
b. 5 Sep 1779 d. Abt 1870
8
Solomon Hobbs
[1.1.1.1.5.3.4.9]
b. 1782 d. 2 May 1854
7
Asael Smith
[1.1.1.1.5.3.5]
b. 7 Mar 1744 d. 31 Oct 1830
Mary Elizabeth Duty
b. 11 Oct 1743 d. 27 May 1836
8
Jesse Smith
[1.1.1.1.5.3.5.1]
b. 20 Apr 1768 d. 16 Mar 1793
Hannah Peabody
b. 1771 d. 28 Sep 1849
9
Benjamin Peabody Smith
[1.1.1.1.5.3.5.1.1]
b. 2 May 1793 d. 15 Jan 1850
Lois Crandall
b. 3 Nov 1799 d. 10 Mar 1882
10
Esther Ann Smith
[1.1.1.1.5.3.5.1.1.1]
b. 15 Oct 1823 d. 24 Dec 1900
10
Martha Wallace Smith
[1.1.1.1.5.3.5.1.1.2]
b. 14 Oct 1825 d. 22 May 1849
10
Edwin Wallace Smith
[1.1.1.1.5.3.5.1.1.3]
b. 13 Apr 1827 d. 1 Sep 1907
10
Henry Storrs Smith
[1.1.1.1.5.3.5.1.1.4]
b. 11 Mar 1829 d. 3 Dec 1852
10
Benjamin Smith
[1.1.1.1.5.3.5.1.1.5]
b. 28 Apr 1833 d. 28 May 1833
10
Peabody Smith
[1.1.1.1.5.3.5.1.1.6]
b. 28 Apr 1833 d. 28 May 1833
10
Adeline Smith
[1.1.1.1.5.3.5.1.1.7]
b. 6 May 1834 d. 20 Aug 1911
10
James Smith
[1.1.1.1.5.3.5.1.1.8]
b. 16 Mar 1836 d. 21 Jan 1840
10
Jane Smith
[1.1.1.1.5.3.5.1.1.9]
b. 16 Mar 1836 d. 18 May 1917
10
Lois Ann Smith
[1.1.1.1.5.3.5.1.1.10]
b. 6 Apr 1838 d. 10 Aug 1922
10
Adelia Clarissa Smith
[1.1.1.1.5.3.5.1.1.11]
b. 12 Jul 1841 d. 6 Apr 1908
9
Eliza Smith
[1.1.1.1.5.3.5.1.2]
b. 9 Mar 1795 d. 22 Jul 1870
Stoddard Hunt
b. 14 Feb 1780 d. 10 Dec 1855
10
Daniel Smith Hunt
[1.1.1.1.5.3.5.1.2.1]
b. 10 Dec 1826 d. 19 Feb 1882
10
Esther Hunt
[1.1.1.1.5.3.5.1.2.2]
b. 10 Apr 1828 d. 1915
10
Fanny Hunt
[1.1.1.1.5.3.5.1.2.3]
b. 8 Sep 1829 d. 30 May 1852
10
Jesse Hunt
[1.1.1.1.5.3.5.1.2.4]
b. 7 Apr 1831 d. 17 Apr 1871
10
Stephen Hunt
[1.1.1.1.5.3.5.1.2.5]
b. 16 Nov 1833 d. 16 Nov 1922
10
Royal Hunt
[1.1.1.1.5.3.5.1.2.6]
b. 22 May 1836 d. 23 Dec 1880
10
Eliza Hunt
[1.1.1.1.5.3.5.1.2.7]
b. 1 Aug 1840 d. 27 Nov 1918
9
Ira Smith
[1.1.1.1.5.3.5.1.3]
b. 30 Jan 1797 d. 5 Mar 1874
Lucy Post
10
Harry Smith
[1.1.1.1.5.3.5.1.3.1]
b. 26 Jul 1824 d. 4 Apr 1906
10
Norman E. Smith
[1.1.1.1.5.3.5.1.3.2]
b. 24 Nov 1825 d. 19 May 1918
10
James M. Smith
[1.1.1.1.5.3.5.1.3.3]
b. 2 Aug 1827 d. 21 Oct 1902
10
Esther Harmon Smith
[1.1.1.1.5.3.5.1.3.4]
b. 19 Feb 1831 d. 24 Dec 1917
10
Hannah P. Smith
[1.1.1.1.5.3.5.1.3.5]
b. 25 Sep 1832 d. 7 Mar 1859
10
Eliza Smith
[1.1.1.1.5.3.5.1.3.6]
b. 27 Jun 1834 d. 15 Dec 1907
10
Jesse Smith
[1.1.1.1.5.3.5.1.3.7]
b. 30 Dec 1837 d. 31 Dec 1917
9
Harvey Smith
[1.1.1.1.5.3.5.1.4]
b. 1 Apr 1799 d. 20 Feb 1872
Betsey M Yurann
b. 1 Jan 1800 d. 12 Jan 1839
10
Charles Chandler Smith
[1.1.1.1.5.3.5.1.4.1]
b. 13 Feb 1827 d. 14 Feb 1870
10
Horace Buck Smith
[1.1.1.1.5.3.5.1.4.2]
b. 24 Aug 1828 d. 10 Jan 1904
10
Elizabeth Smith
[1.1.1.1.5.3.5.1.4.3]
b. 1829
10
Lucy E. Smith
[1.1.1.1.5.3.5.1.4.4]
b. 7 Apr 1830 d. 4 Apr 1842
10
Betsey M. Smith
[1.1.1.1.5.3.5.1.4.5]
b. 7 May 1832 d. 8 May 1832
10
James Renwick Smith
[1.1.1.1.5.3.5.1.4.6]
b. 5 Sep 1833 d. 4 Apr 1842
10
Jason Smith
[1.1.1.1.5.3.5.1.4.7]
b. 27 Jul 1835 d. 23 Mar 1881
10
William N Smith
[1.1.1.1.5.3.5.1.4.8]
b. 22 Oct 1838 d. 6 May 1911
Electa Jenne
b. 25 Nov 1822 d. 17 Nov 1870
10
Benjamin C
[1.1.1.1.5.3.5.1.4.9]
b. 24 Jul 1854 d. 2 May 1872
10
Jane
[1.1.1.1.5.3.5.1.4.10]
b. 30 Sep 1855 d. 18 Oct 1918
10
Friend Smith
[1.1.1.1.5.3.5.1.4.11]
b. 19 Aug 1858 d. 8 Feb 1936
10
Miranda Smith
[1.1.1.1.5.3.5.1.4.12]
b. 15 Feb 1860 d. 26 May 1934
10
King E. Smith
[1.1.1.1.5.3.5.1.4.13]
b. 19 Mar 1862 d. 12 Jun 1865
9
Harriet Tupper Smith
[1.1.1.1.5.3.5.1.5]
b. 8 Apr 1801 d. Apr 1879
+
Ezra Martindall
9
Stephen Smith
[1.1.1.1.5.3.5.1.6]
b. 2 May 1803 d. 16 Apr 1851
+
Hannah Miller Hunt
b. Abt 1805
9
Mary Polly Smith
[1.1.1.1.5.3.5.1.7]
b. 4 May 1805 d. 13 Jun 1870
+
Hiram Chapman
b. 8 Apr 1795 d. 1867
9
Catherine Smith
[1.1.1.1.5.3.5.1.8]
b. 13 Jul 1807 d. 2 May 1888
James Kelsey
b. 9 Jun 1801 d. 9 Sep 1883
10
Hannah Kelsey
[1.1.1.1.5.3.5.1.8.1]
b. 2 Mar 1829 d. 20 Nov 1905
10
Amanda Kelsey
[1.1.1.1.5.3.5.1.8.2]
b. 24 Oct 1830 d. 1 Jun 1914
10
Eleanor Amelia Kelsey
[1.1.1.1.5.3.5.1.8.3]
b. 5 Jul 1832 d. 9 Sep 1900
10
James Edwin Kelsey
[1.1.1.1.5.3.5.1.8.4]
b. 5 Jul 1832 d. 27 Oct 1910
10
Julius Marcellus Kelsey
[1.1.1.1.5.3.5.1.8.5]
b. 21 Jul 1836 d. 3 Nov 1905
10
Royal Smith Kelsey
[1.1.1.1.5.3.5.1.8.6]
b. 7 Jun 1839 d. 24 Sep 1865
10
Mark Kelsey
[1.1.1.1.5.3.5.1.8.7]
b. 8 Aug 1843 d. 26 Nov 1877
9
Royal Smith
[1.1.1.1.5.3.5.1.9]
b. 2 Jul 1809 d. 1882
+
Happeelona Peck
9
Sarah B Smith
[1.1.1.1.5.3.5.1.10]
b. 16 Dec 1810 d. 2 Oct 1887
+
Henry Barnard
+
Christene Smith
8
Priscilla Smith
[1.1.1.1.5.3.5.2]
b. 21 Oct 1769 d. 17 Apr 1860
John Curtis Waller
9
Calvin C. Waller
[1.1.1.1.5.3.5.2.1]
b. 6 Jun 1797 d. Jun 1864
9
Dolly Waller
[1.1.1.1.5.3.5.2.2]
b. 16 Oct 1799 d. 20 Jun 1800
9
Marshall Waller
[1.1.1.1.5.3.5.2.3]
b. 18 Mar 1801
9
Royal H Waller
[1.1.1.1.5.3.5.2.4]
b. 29 Nov 1802 d. 29 Sep 1866
9
Dudley C Waller
[1.1.1.1.5.3.5.2.5]
b. 29 Sep 1804 d. Abt 1868
+
Mrs Dudley C Waller
b. Abt 1806
9
Bushrod W Waller
[1.1.1.1.5.3.5.2.6]
b. 18 Oct 1806
9
Silas Waller
[1.1.1.1.5.3.5.2.7]
b. 1 Jan 1809 d. 2 Jun 1866
Marietta Smith
b. 1811
10
Francis Waller
[1.1.1.1.5.3.5.2.7.1]
b. 9 Feb 1841 d. 27 Oct 1844
10
Ellen Waller
[1.1.1.1.5.3.5.2.7.2]
b. 11 Sep 1845
10
Anna Buffington
[1.1.1.1.5.3.5.2.7.3]
b. 17 Dec 1848 d. 22 Jan 1852
10
Lilla Waller
[1.1.1.1.5.3.5.2.7.4]
b. 21 Dec 1851 d. 20 Jan 1929
9
Salley P Waller
[1.1.1.1.5.3.5.2.8]
b. 31 Oct 1810 d. 15 Aug 1874
9
John J Waller
[1.1.1.1.5.3.5.2.9]
b. 9 Sep 1812 d. 5 Nov 1812
+
Michael Smith
8
Joseph Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3]
b. 12 Jul 1771 d. 14 Sep 1840
Lucy Mack
b. 8 Jul 1775 d. 14 May 1856
9
Son Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.1]
b. 1797 d. 1797
9
Daughter Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.2]
b. 1797 d. 1797
9
Alvin Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.3]
b. 11 Feb 1798 d. 19 Nov 1823
9
Hyrum Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4]
b. 9 Feb 1800 d. 27 Jun 1844
Jerusha Barden
b. 15 Feb 1805 d. 13 Oct 1837
10
Lovina Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.1]
b. 16 Sep 1827 d. 8 Oct 1876
10
Mary Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.2]
b. 27 Jun 1829 d. 29 May 1832
10
John Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.3]
b. 22 Sep 1832
10
Hyrum Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.4]
b. 27 Apr 1834 d. 21 Sep 1841
10
Jerusha Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.5]
b. 13 Jan 1836 d. 27 Jun 1912
10
Sarah Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.6]
b. 2 Oct 1837 d. 6 Nov 1876
Mary Fielding
b. 21 Jul 1801 d. 21 Sep 1852
10
Joseph Fielding Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7]
b. 13 Nov 1838 d. 19 Nov 1918
+
Levira Annette Clark Smith
b. 29 Apr 1842 d. 18 Dec 1888
Julina Lambson
b. 18 Jun 1849 d. 10 Jan 1936
11
Edward Aurthur Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.1]
b. 1 Nov 1858 d. 17 Jul 1911
11
Mercy Josephine Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.2]
b. 14 Aug 1867 d. 6 Jun 1870
11
Mary Sophronia Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.3]
b. 7 Oct 1869 d. 5 Jan 1948
11
Donnette Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.4]
b. 17 Sep 1872 d. 16 Sep 1961
11
Joseph Fielding Smith, Jr
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.5]
b. 19 Jul 1876 d. 2 Jul 1972
Emily Louie Shurtliff
b. 16 Jun 1876 d. 30 Mar 1908
12
Josephine Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.5.1]
b. 18 Sep 1902 d. 16 Sep 1995
12
Julina Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.5.2]
b. 5 Feb 1906 d. 9 May 1997
Ethel Georgina Reynolds
b. 23 Oct 1889 d. 26 Aug 1937
12
Emily Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.5.3]
b. 9 Aug 1909 d. 21 Aug 1994
12
Naomi Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.5.4]
b. 16 Nov 1910 d. 15 Oct 1979
12
Lois Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.5.5]
b. 26 Mar 1912 d. 23 Jan 1981
12
Joseph Fielding Smith, Jr
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.5.6]
b. 18 Dec 1913 d. 23 Aug 1974
12
Amelia Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.5.7]
b. 21 Jun 1916 d. 22 Sep 2005 [
=>
]
12
Lewis Warren Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.5.8]
b. 10 Mar 1918 d. 12 Dec 1944
12
George Reynolds Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.5.9]
b. 13 Feb 1921 d. 28 Oct 1982
12
Living
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.5.10]
12
Living
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.5.11]
+
Jessie Ella Evans
b. 29 Dec 1902 d. 3 Aug 1971
11
David Asael Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.6]
b. 24 May 1879 bur. 9 Apr 1952
11
George Carlos Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.7]
b. 14 Oct 1881 d. 25 Feb 1931
11
Julina Clarissa Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.8]
b. 10 Feb 1884 d. 1 Aug 1923
11
Elias Wesley Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.9]
b. 21 Apr 1886 d. 28 Dec 1970
11
Emily Jane Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.10]
b. 11 Sep 1888 d. 12 Dec 1982
11
Rachel Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.11]
b. 11 Dec 1890 d. 14 Dec 1986
11
Edith Eleanor Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.12]
b. 3 Jan 1894 d. 21 May 1987
11
Marjorie Virginia Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.13]
b. 7 Dec 1906 d. 17 Nov 1994
Sarah Ellen Richards
b. 25 Aug 1850 d. 22 Mar 1915
11
Sarah Ellen Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.14]
b. 5 Feb 1869 d. 11 Feb 1869
11
Leonora Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.15]
b. 30 Jan 1871 bur. 26 Dec 1907
11
Joseph Richards Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.16]
b. 22 Feb 1873 d. 2 Oct 1954
11
Heber John Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.17]
b. 3 Jul 1876 d. 3 Mar 1877
11
Rhoda Ann Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.18]
b. 20 Jul 1878 d. 6 Jul 1879
11
Minerva Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.19]
b. 30 Apr 1880 d. 24 Jan 1958
11
Alice Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.20]
b. 27 Jul 1882 d. 29 Apr 1901
11
Willard Richards Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.21]
b. 20 Nov 1884 d. 11 Sep 1972
Florence Grant
b. 7 Feb 1883 d. 6 Mar 1977
12
Willard Grant Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.21.1]
b. 12 May 1911 d. 16 Dec 1996
12
Florence Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.21.2]
b. 7 Apr 1913 d. 5 Mar 2017
12
Richards Grant Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.21.3]
b. 10 Mar 1915 d. 6 Mar 2000
12
Briant Grant Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.21.4]
b. 15 Dec 1916 d. 6 Jan 2006
12
Heber Joseph Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.21.5]
b. 23 Dec 1918 d. 26 Nov 1943
12
Howard Grant Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.21.6]
b. 13 Mar 1921 d. 28 May 2010
12
Sarah Ellen Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.21.7]
b. 5 May 1923 d. 23 Oct 1980 [
=>
]
12
Paul Grant Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.21.8]
b. 19 May 1925 d. 21 Jan 2000
11
Franklin Richards Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.22]
b. 12 May 1888 d. 25 Dec 1967
11
Jeanetta Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.23]
b. 25 Aug 1891 d. 27 Jan 1932
11
Asenath Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.24]
b. 28 Dec 1896 d. 3 Aug 1982
Edna Lambson
b. 3 Mar 1851
11
Hyrum Mack Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.25]
b. 21 Mar 1872 d. 23 Jan 1918
11
Alvin Fielding Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.26]
b. 7 Aug 1874 d. 4 Jan 1948
11
Alfred Jason Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.27]
b. 13 Dec 1876 d. 6 Apr 1878
11
Edna Melissa Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.28]
b. 6 Oct 1879 d. 26 Oct 1958
11
Albert Jesse Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.29]
b. 16 Sep 1881 d. 25 Aug 1883
11
Robert Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.30]
b. 12 Nov 1883 d. 4 Feb 1886
11
Emma Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.31]
b. 21 Aug 1888 d. 29 Dec 1969
11
Zina Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.32]
b. 11 Oct 1890 d. 25 Oct 1915
11
Ruth Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.33]
b. 21 Dec 1893 d. 17 Mar 1898
11
Martha Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.34]
b. 12 May 1897 d. 7 Aug 1977
Alice Ann Kimball
b. 6 Sep 1858 d. 19 Dec 1946
11
Alice May Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.35]
b. 11 Oct 1877 d. 20 Oct 1920
11
Heber Chase Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.36]
b. 19 Nov 1881 d. 29 Dec 1971
11
Charles Coulson Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.37]
b. 19 Nov 1881 d. 21 Apr 1933
11
Lucy Mack Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.38]
b. 14 Apr 1890 d. 24 Nov 1933
11
Andrew Kimball Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.39]
b. 6 Jan 1893 d. 23 Aug 1951
11
Jesse Kimball Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.40]
b. 21 May 1896 d. 21 May 1953
11
Fielding Kimball Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.41]
b. 9 Apr 1900 d. 20 Oct 1974
Mary Taylor Schwartz
b. 30 Apr 1865 d. 5 Dec 1956
11
John Schwartz Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.42]
b. 20 Aug 1888 d. 3 Aug 1889
11
Calvin Schwartz Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.43]
b. 29 May 1890
11
Samuel Schwartz Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.44]
b. 26 Oct 1892 d. 10 May 1983
11
James Schwartz Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.45]
b. 13 Nov 1894 d. 6 Nov 1950
11
Agnes Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.46]
b. 3 Nov 1897 d. 9 Mar 1966
11
Silas Schwartz Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.47]
b. 3 Jan 1900 d. 23 Apr 1983
11
Royal Grant Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.7.48]
b. 21 May 1906 d. 30 May 1971
10
Martha Ann Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.8]
b. 14 May 1841 d. 19 Oct 1923
William Jasper Harris
b. 25 Oct 1836 d. 24 Apr 1909
11
William Jasper Harris, Jr
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.8.1]
b. 4 Aug 1859 d. 23 Aug 1926
11
Joseph Albert Harris
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.8.2]
b. 19 Aug 1861 d. 28 May 1911
11
Hyrum Smith Harris
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.8.3]
b. 15 Aug 1863 d. 24 Feb 1924
11
Mary Emily Harris
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.8.4]
b. 23 Oct 1865 d. 25 Nov 1947
11
Franklin Hill Harris
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.8.5]
b. 11 Sep 1867 d. 5 Feb 1947
11
Lucy Smith Harris
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.8.6]
b. 10 Mar 1870 d. 25 Jul 1903
11
John Fielding Harris
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.8.7]
b. 28 Jun 1872 d. 28 Nov 1946
11
Mercy Ann Harris
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.8.8]
b. 30 Mar 1874 d. 23 Jan 1905
11
Zina Christine Harris
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.8.9]
b. 13 May 1876 d. 16 Mar 1958
11
Martha Artemesia Harris
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.8.10]
b. 27 Jun 1879 d. 12 Aug 1965
11
Sarah Lovina Harris
[1.1.1.1.5.3.5.3.4.8.11]
b. 8 Dec 1882 d. 21 Apr 1961
+
Catherine Phillips
b. 1 Aug 1819 d. 26 Sep 1905
+
Mercy Rachel Fielding
b. 15 Jun 1807 d. 15 Sep 1893
9
Sophronia Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.5]
b. 17 May 1803 d. 28 Oct 1876
Calvin W Stoddard
b. 7 Sep 1801 d. 19 Nov 1836
10
Eunice Stoddard
[1.1.1.1.5.3.5.3.5.1]
b. 22 Mar 1830 d. 24 Jun 1831
10
Mariah Stoddard
[1.1.1.1.5.3.5.3.5.2]
b. 12 Apr 1832 d. 8 Oct 1896
+
William McCleary
b. 9 Oct 1793 d. Jun 1846
9
Samuel Harrison Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.6]
b. 13 Mar 1808 d. 30 Jul 1844
Mary Bailey
b. 20 Dec 1808 d. 25 Jan 1841
10
Susanna Bailey Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.6.1]
b. 27 Oct 1835 d. 14 Dec 1905
10
Mary Bailey Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.6.2]
b. 27 Mar 1837 d. 14 Oct 1916
10
Samuel Harrison Bailey Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.6.3]
b. 1 Aug 1838 d. 12 Jun 1914
10
Lucy Bailey Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.6.4]
b. 6 Jan 1841 d. Jan 1841
Levira Clark
b. 30 Jul 1815 d. 1 Jan 1893
10
Levira Annette Clark Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.6.5]
b. 29 Apr 1842 d. 18 Dec 1888
+
Joseph Fielding Smith
b. 13 Nov 1838 d. 19 Nov 1918
10
Lovisa Clark Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.6.6]
b. 28 Aug 1843 d. Dec 1843
10
Lucy Jane Clark Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.6.7]
b. 20 Aug 1844 d. 1844
9
Ephraim Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.7]
b. 13 Mar 1810 d. 24 Mar 1810
9
William B Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.8]
b. 13 Mar 1811 d. 13 Nov 1893
Carolina Amanda Grant
b. 22 Jan 1814 d. 22 May 1845
10
Mary Jane Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.8.1]
b. 7 Jan 1834 d. 21 Dec 1878
10
Caroline L Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.8.2]
b. Aug 1839 d. 9 Jan 1878
Roxie Ann Grant
b. 16 Mar 1825 d. 30 Mar 1900
10
Thalia Grant Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.8.3]
b. 21 Sep 1848 d. 27 Nov 1924
10
Hyrum Wallace Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.8.4]
b. 17 Aug 1850 d. 27 Jan 1935
Eliza Elise Jane Sanborn
b. 16 Apr 1827 d. 7 Mar 1889
10
William Enoch Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.8.5]
b. 23 Jul 1858 d. 13 Feb 1930
10
Edson Don Carlos Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.8.6]
b. 16 Sep 1862 d. 13 Feb 1939
10
Louise Mae "Loie " Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.8.7]
b. 8 May 1866 d. 10 May 1925
+
Rosella Goyette
b. 16 May 1830 d. 6 Apr 1923
9
Katherine Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.9]
b. 28 Jul 1813 d. 1 Feb 1900
Wilkins Jenkins Salisbury
b. 6 Jan 1809 d. 27 Nov 1853
10
Elizabeth Salisbury
[1.1.1.1.5.3.5.3.9.1]
b. 9 Apr 1832 d. 15 Jul 1832
10
Lucy Salisbury
[1.1.1.1.5.3.5.3.9.2]
b. 3 Oct 1834 d. 18 Oct 1892
10
Reverend Solomon Jenkins Salisbury
[1.1.1.1.5.3.5.3.9.3]
b. 18 Sep 1835 d. 12 Jan 1927
10
Alvin Salisbury
[1.1.1.1.5.3.5.3.9.4]
b. 7 Jun 1838 d. 21 Aug 1880
10
Reverend Don C. Salisbury
[1.1.1.1.5.3.5.3.9.5]
b. 25 Oct 1840 d. 6 Apr 1919
10
Emma C Salisbury
[1.1.1.1.5.3.5.3.9.6]
b. 25 Mar 1844 d. 10 Oct 1846
10
Lorin Ephraim Salisbury
[1.1.1.1.5.3.5.3.9.7]
b. 4 May 1845 d. 18 Nov 1849
10
Frederick Vilian Salisbury
[1.1.1.1.5.3.5.3.9.8]
b. 27 Jan 1850 d. 24 Feb 1934
+
Joseph Younger
b. 1805 d. 1900
9
Don Carlos Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.10]
b. 25 Mar 1816 d. 7 Aug 1841
Agnes Moultin Coolbrith
b. 11 Jul 1811 d. 26 Dec 1876
10
Agnes Charlotte Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.10.1]
b. 7 Aug 1836 d. 31 Jan 1873
10
Sophronia C. Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.10.2]
b. 22 Apr 1838 d. 3 Oct 1843
10
Josephine Donna "Ina Coolbrith" Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.10.3]
b. 10 Mar 1841 d. 29 Feb 1928
Robert Bruce Carsley
b. 6 Jun 1833 d. 14 Aug 1905
11
Son 1 Carsley
[1.1.1.1.5.3.5.3.10.3.1]
b. 1860 d. 1860
11
Son 2 Carsley
[1.1.1.1.5.3.5.3.10.3.2]
b. 1861 d. Bef 1865
9
Lucy Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.11]
b. 18 Jul 1821 d. 9 Dec 1882
Arthur Millikin
b. 9 May 1817 d. 23 Apr 1882
10
Don Carlos Smith Millikin
[1.1.1.1.5.3.5.3.11.1]
b. 13 Oct 1843 d. 26 Nov 1932
10
Sarah M Millikin
[1.1.1.1.5.3.5.3.11.2]
b. 13 Sep 1844 d. 23 Nov 1934
10
George William Dell Millikin
[1.1.1.1.5.3.5.3.11.3]
b. 4 Mar 1848 d. 16 Jan 1913
10
Florence Arabella Millikin
[1.1.1.1.5.3.5.3.11.4]
b. 23 May 1850 d. 21 Oct 1927
10
Julia Amelia Millikin
[1.1.1.1.5.3.5.3.11.5]
b. 17 Jun 1853 d. 7 Jun 1888
10
Frances A. Millikin
[1.1.1.1.5.3.5.3.11.6]
b. 26 Oct 1856 d. 14 Mar 1858
10
Charles Arthur Millikin
[1.1.1.1.5.3.5.3.11.7]
b. 31 Aug 1858 d. 12 May 1884
10
Clara Irene Millikin
[1.1.1.1.5.3.5.3.11.8]
b. 23 Aug 1861 d. 26 Mar 1948
10
Clarence Hyrum Millikin
[1.1.1.1.5.3.5.3.11.9]
b. 26 Mar 1865 d. 5 Apr 1922
9
Joseph Smith, Jr
[1.1.1.1.5.3.5.3.12]
b. 23 Dec 1805 d. 27 Jun 1844
Emma Hale
b. 10 Jul 1804 d. 30 Apr 1879
10
Alvin Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.1]
b. 15 Jun 1828 d. 15 Jun 1828
10
Joseph Murdock Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.2]
b. 30 Apr 1831 d. 29 Mar 1832
10
Julia Murdock Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.3]
b. 30 Apr 1831 d. 12 Sep 1880
+
Elisha Dixon
b. 1827 d. 1850
+
John J Middleton
b. Abt 1827 d. Abt 1869
10
Thaddeus Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.4]
b. 30 Apr 1831 d. 30 Apr 1831
10
Louisa Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.5]
b. 30 Apr 1831 d. 30 Apr 1831
10
Joseph Smith, III
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.6]
b. 6 Nov 1832 d. 10 Dec 1914
Emmeline Griswold
b. 12 Mar 1838 d. 25 Mar 1869
11
Emma Josepha Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.6.1]
b. 28 Jul 1857 d. 30 Nov 1940
Alexander McCallum
b. 4 Apr 1848 d. 8 Oct 1928
12
Joseph Alma McCallum
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.6.1.1]
b. 19 Sep 1878 d. 1967 [
=>
]
12
Arthur Alexander McCallum
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.6.1.2]
b. 2 Jun 1882 d. 27 Mar 1937
12
William James McCallum
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.6.1.3]
b. 1 Aug 1890 d. 10 Oct 1963
12
Oscar MacEo McCallum
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.6.1.4]
b. 12 Jun 1896 d. 20 Feb 1898
11
Evelyn Rebecca Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.6.2]
b. 25 Jan 1859 d. 30 Sep 1859
11
Carrie Lucinda Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.6.3]
b. 15 Sep 1861 d. 27 Apr 1944
Francis Marion Weld
b. 9 Sep 1858 d. 4 Jul 1938
12
Emma Rebecca Weld
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.6.3.1]
b. 3 Jul 1889 d. Abt 1975 [
=>
]
11
Zaide Viola Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.6.4]
b. 25 Apr 1863 d. 8 Jan 1891
Richard Savary Salyards
b. 16 Jun 1857 d. 27 Nov 1944
12
Emma Marie Salyards
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.6.4.1]
b. 8 Aug 1884 d. 16 Sep 1886
12
Zaide Aileen Salyards
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.6.4.2]
b. 11 Jan 1887 d. 27 May 1973
12
Joseph Richard Salyards
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.6.4.3]
b. 18 Aug 1888 [
=>
]
12
Richard Savary Salyards
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.6.4.4]
b. 21 Jun 1890 d. 28 Feb 1988 [
=>
]
11
Joseph Arthur Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.6.5]
b. 12 Aug 1865 d. 12 Mar 1866
Bertha Madison
b. 16 Jul 1843 d. 19 Oct 1896
11
David Carlos Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.6.6]
b. 14 Aug 1870 d. 24 Jan 1886
11
Mary Audentia Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.6.7]
b. 23 Mar 1872 d. 5 May 1963
11
Frederick Madison Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.6.8]
b. 21 Jan 1874 d. 20 Mar 1946
11
Israel Alexander Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.6.9]
b. 2 Feb 1876 d. 14 Jun 1958
11
Kenneth Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.6.10]
b. 6 Oct 1877 d. 6 Oct 1877
11
Bertha Azubah Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.6.11]
b. 15 Oct 1878 d. 14 Oct 1884
11
Hale Washington Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.6.12]
b. 22 Feb 1881 d. 10 Jul 1956
11
Blossom Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.6.13]
b. 1 May 1883 d. 1 May 1883
11
Lucy Yeteve Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.6.14]
b. 11 Dec 1884 d. 4 Aug 1945
Ada Rachel Clark
b. 23 Jul 1871 d. 20 Oct 1915
11
Reginald Archer Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.6.15]
b. 26 Dec 1898 d. 20 Jun 1969
11
William Wallace Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.6.16]
b. 18 Nov 1900 d. 4 Aug 1989
11
Reginald Archer Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.6.17]
b. 8 Jan 1903 d. 28 Sep 1974
10
Frederick Granger Williams Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.7]
b. 20 Jun 1836 d. 13 Apr 1862
Anna Marie Jones
b. 7 Apr 1841 d. 11 Oct 1901
11
Alice Fredericka Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.7.1]
b. 27 Nov 1858 d. 5 Nov 1932
10
Alexander Hale Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8]
b. 2 Jun 1838 d. 12 Aug 1909
Elizabeth Agnes Kendall
b. 16 Jun 1845 d. 7 May 1919
11
Frederick Alexander Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.1]
b. 19 Jan 1862 d. 25 Jun 1954
Mary Angelina Walker
b. 18 Mar 1867 d. 3 Dec 1931
12
Alexander David Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.1.1]
b. 18 Aug 1885 d. 20 Oct 1891
12
Gladys Inez Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.1.2]
b. 17 Dec 1886 d. 17 Jul 1983 [
=>
]
12
Joy May Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.1.3]
b. 13 Jul 1889 d. 29 Jul 1961 [
=>
]
12
Glaud Leslie Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.1.4]
b. 19 Jan 1891 d. 16 Feb 1986 [
=>
]
12
Freda Saloam Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.1.5]
b. 3 Dec 1892 d. 13 Oct 1974
12
Winsome Lavinia Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.1.6]
b. 20 Aug 1896 d. 30 Nov 1986 [
=>
]
12
Frederick Augenstein Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.1.7]
b. 19 Mar 1899 d. Jan 1966
12
Harold Legrand Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.1.8]
b. 12 Jan 1902 d. 19 Jul 1992
+
Margaret Esther Clark
b. 1 Sep 1901 d. 3 Aug 1987
11
Vida Elizabeth Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.2]
b. 16 Jan 1865 d. 3 Jan 1945
Heman Conoman Smith
b. 27 Sep 1850 d. 17 Apr 1919
12
Heman Hale Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.2.1]
b. 28 Apr 1887 d. 11 Mar 1962 [
=>
]
12
Vida Inez Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.2.2]
b. 16 Jan 1889 d. 24 Oct 1964
12
Anna Earlita Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.2.3]
b. 28 Nov 1890 d. 5 Jun 1975 [
=>
]
12
Lois Elizabeth Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.2.4]
b. 3 Nov 1892 d. 27 Mar 1914 [
=>
]
11
Ina Inez Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.3]
b. 22 Nov 1866 d. 18 Aug 1945
Sidney Garden Wright
b. 26 Jul 1869 d. 8 Aug 1936
12
Claud Kendall Wright
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.3.1]
b. 21 Mar 1892 d. 6 Oct 1972 [
=>
]
12
Vida Grace Wright
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.3.2]
b. 22 Apr 1893 d. 11 Jul 1970 [
=>
]
12
Leland Eric Wright
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.3.3]
b. 30 Dec 1895 d. 11 Nov 1977 [
=>
]
12
Mavis Myra Wright
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.3.4]
b. 30 Dec 1897 d. 15 Aug 1960 [
=>
]
12
Warren Alford Wright
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.3.5]
b. 28 Mar 1899 d. 26 Feb 1980 [
=>
]
12
Edgar Milton Wright
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.3.6]
b. 1 May 1901 d. 2 May 1961 [
=>
]
12
Glory Carmen Wright
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.3.7]
b. 14 Aug 1903 d. 4 Nov 1968
12
Byron Granville Wright
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.3.8]
b. 19 Feb 1906 d. 3 Nov 1974 [
=>
]
12
Marian Inez Wright
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.3.9]
b. 17 Nov 1907 d. 28 Jul 1987 [
=>
]
12
Gwen Hero Wright
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.3.10]
b. 23 Oct 1909 d. 28 Jul 1987
11
Emma Belle Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.4]
b. 17 Mar 1869 d. 3 May 1960
William Forrester Kennedy
b. 5 Jun 1863 d. 22 Mar 1938
12
Arthur Frederick Kennedy
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.4.1]
b. 25 May 1889 d. 1 Jul 1889
12
Joseph Douglas Kennedy
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.4.2]
b. 14 Oct 1891 d. 14 Oct 1891
12
Cecile Grace Kennedy
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.4.3]
b. 3 Jun 1894 d. 9 May 1895
12
Roger Alexander Kennedy
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.4.4]
b. 5 Nov 1897 d. 15 Dec 1933 [
=>
]
12
Glenna Marie Kennedy
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.4.5]
b. 3 Nov 1900 d. 30 Jul 1986
11
Don Alvin Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.5]
b. 17 May 1871 d. 8 Sep 1904
Susan Zeanette Pearsall
b. 21 Apr 1873 d. 22 Jun 1957
12
Velora Belle Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.5.1]
b. 13 Dec 1893 d. 28 Dec 1993
12
Carlos McAllister Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.5.2]
b. 22 May 1895 d. Nov 1981 [
=>
]
12
Beatrice Adelle Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.5.3]
b. 19 Aug 1896 d. 21 Jun 1989 [
=>
]
12
LaJune Harriet Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.5.4]
b. 1 Jul 1899 d. 9 Aug 1985
12
Don Marion Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.5.5]
b. 28 Oct 1901 d. 13 Nov 1983 [
=>
]
12
Maxwell Alexis Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.5.6]
b. 13 Apr 1903 d. 17 Feb 1961 [
=>
]
11
Eva Grace Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.6]
b. 1 Mar 1874 d. 26 Mar 1893
Forrest Lamont Madison
b. 1872 d. 18 Mar 1945
12
Lamont Kendall Madison
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.6.1]
b. 17 Mar 1893 d. 3 Apr 1963 [
=>
]
11
Joseph George Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.7]
b. 7 May 1877 d. 27 Dec 1936
Nellie May Daudelin
b. 19 Jun 1879 d. 2 Apr 1935
12
Josephine Alexandria Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.7.1]
b. 20 Nov 1904 d. 6 Aug 1985 [
=>
]
12
Paul Daudelin Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.7.2]
b. 1 Mar 1908 d. Sep 1975
11
Arthur Marion Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.8]
b. 8 Feb 1880 d. 21 Mar 1964
Estella Almira Danielson
b. 7 Mar 1884 d. 23 Jun 1916
12
Verl Marion Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.8.1]
b. 21 Apr 1905 d. 3 Aug 1980
12
Carl K Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.8.2]
b. 5 Mar 1907 d. 1966
12
Alexander Martin Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.8.3]
b. 7 Feb 1909 d. 30 Sep 1982 [
=>
]
12
Kenneth Julian Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.8.4]
b. 7 Mar 1911 d. 16 Jun 1988 [
=>
]
12
Arthur Granger Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.8.5]
b. 18 Mar 1916 d. 17 Mar 2012
Minnie Catherine Smith
b. 20 May 1894 d. 30 Jan 1988
12
Georgia May Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.8.6]
b. 22 Feb 1923 d. Jul 2009 [
=>
]
12
Myrle Lee Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.8.7]
b. 14 Sep 1925 d. 21 Nov 1985
11
Coral Cecil Rebekah Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.9]
b. 29 Oct 1882 d. 17 Aug 1968
Louis Hurst Horner
b. 21 Sep 1878 d. 18 Feb 1970
12
Louis Brainard Horner
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.9.1]
b. 26 Oct 1906 d. 13 Aug 1980
12
Elizabeth Grace Horner
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.9.2]
b. 16 Apr 1910 d. 19 Jul 1991 [
=>
]
12
James Brandon Horner
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.9.3]
b. 5 Jul 1912 d. 23 Jan 1975
12
Ina Lorena Horner
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.8.9.4]
b. 30 Aug 1915 d. 1 Dec 2004 [
=>
]
10
Don Carlos Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.9]
b. 13 Jun 1840 d. 15 Sep 1841
10
Thomas Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.10]
b. 6 Feb 1842 d. 6 Feb 1842
10
David Hyrum Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.11]
b. 17 Nov 1844 d. 29 Aug 1904
Clara Charlotte Hartshorn
b. 18 May 1851 d. 9 Aug 1926
11
Elbert Aoriul Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.11.1]
b. 8 Mar 1871 d. 15 May 1959
Clara Abigale Cochran
b. 12 Jan 1874 d. 30 Oct 1948
12
Lawrence David Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.11.1.1]
b. 3 Jun 1896 d. 17 Jun 1896
12
Ronald Gibson Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.11.1.2]
b. 10 Oct 1902 d. 4 Feb 1988
12
Lynn Elbert Smith
[1.1.1.1.5.3.5.3.12.11.1.3]
b. 20 Jan 1911 d. 1 Jun 1992 [
=>
]
+
Agnes Moultin Coolbrith
b. 11 Jul 1811 d. 26 Dec 1876
+
Fanny Young
b. 8 Nov 1787 d. 11 Jun 1859
+
Eliza Roxey Snow
b. 21 Jan 1804 d. 5 Dec 1887
+
Francis Ward "Fanny" Alger
b. 30 Sep 1817 d. 29 Nov 1889
+
Louisa Beaman
b. 7 Feb 1815 d. 15 May 1850
+
Helen Mar Kimball
b. 25 Aug 1828 bur. 15 Nov 1896
+
Emily Dow Partridge
b. 28 Feb 1824 d. 9 Dec 1899
+
Olive Grey Frost
b. 24 Jul 1816 d. 8 Oct 1845
+
Rhoda Richards
b. 8 Aug 1784 d. 17 Jan 1879
+
Lucy Walker
b. 30 Apr 1826 d. 1 Oct 1910
+
Sarah Ann Whitney
b. 22 Mar 1825 d. 4 Sep 1873
+
Prescinda Lothrop Huntington
b. 7 Sep 1810 d. 1 Feb 1892
+
Eliza Partridge
b. 20 Apr 1820 bur. 2 Mar 1886
+
Desdemona Wadsworth Fullmer
b. 6 Oct 1809 d. 9 Feb 1886
+
Zina Diantha Huntington
b. 31 Jan 1821 d. 28 Aug 1901
+
Mary Elizabeth Rollins
b. 9 Apr 1818 d. 17 Dec 1913
+
Martha McBride
b. 17 Mar 1805 d. 20 Nov 1901
+
Sylvia Porter Sessions
b. 31 Jul 1818 d. 12 Apr 1882
+
Patty Bartlett
b. 4 Feb 1795 d. 14 Dec 1892
+
Maria Lawrence
b. 18 Dec 1823 d. 1847
+
Sarah A Lawrence
b. 13 May 1826 d. 28 Nov 1872
8
Asahel Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4]
b. 21 May 1773 d. 21 Jul 1848
Elizabeth Shellenger
b. 1 Dec 1785 d. 14 Oct 1846
9
Elias Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.1]
b. 6 Sep 1804 d. 24 Jun 1888
Amy Jane King
b. 2 Oct 1836 d. 8 Nov 1913
10
Silas Thomas Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.1.1]
b. 4 May 1857 d. 1 May 1945
10
Jesse Moroni Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.1.2]
b. 21 Nov 1858 d. 14 Mar 1937
+
Sarah Ann Smith
b. 11 Jul 1868 d. 2 Feb 1900
10
Rebecca Jane Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.1.3]
b. 23 Sep 1860 d. 18 Jul 1923
10
Mary Alzina Knapp Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.1.4]
b. 16 May 1865 d. 20 Jan 1953
10
Martha Priscilla Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.1.5]
b. 30 May 1865 d. 18 Apr 1946
10
Amy Esther Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.1.6]
b. 11 Aug 1867 d. 21 Sep 1910
10
Angelina Adelia Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.1.7]
b. 11 Jul 1869 d. 8 Mar 1950
10
Franklin Elias Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.1.8]
b. 13 Dec 1871 d. 24 Jul 1917
10
Sarah Susannah Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.1.9]
b. 26 Mar 1873 d. 25 Apr 1952
10
Hiram Bennett Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.1.10]
b. 2 Feb 1877 d. 29 Mar 1951
Lucy Brown
b. 4 Jan 1821 d. 3 Apr 1896
10
Emily Jane Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.1.11]
b. 28 Oct 1850 d. 8 May 1878
Wilford Woodruff, Jr
b. 22 Mar 1840 d. 6 May 1921
11
Lucy Emily Woodruff
[1.1.1.1.5.3.5.4.1.11.1]
b. 10 Jan 1869 d. 5 Nov 1937
George Albert Smith
b. 4 Apr 1870 d. 4 Apr 1951
12
Emily Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.1.11.1.1]
b. 20 Nov 1895 d. 28 Feb 1973
12
Edith Elliott
[1.1.1.1.5.3.5.4.1.11.1.2]
b. 10 Nov 1899 d. 13 Jun 1977
12
George Albert Smith, Jr
[1.1.1.1.5.3.5.4.1.11.1.3]
b. 10 Sep 1905 d. 11 Oct 1969
11
Wilford Smith Woodruff
[1.1.1.1.5.3.5.4.1.11.2]
b. 25 Sep 1871 d. 26 Nov 1955
11
Elias Smith Woodruff
[1.1.1.1.5.3.5.4.1.11.3]
b. 15 Dec 1873 d. 16 Nov 1941
Nellie Maria Davis
b. 5 Mar 1872 d. 14 Oct 1960
12
Nettie Woodruff
[1.1.1.1.5.3.5.4.1.11.3.1]
b. 3 Nov 1902 d. 24 Jun 1988
12
Asahel Davis Woodruff
[1.1.1.1.5.3.5.4.1.11.3.2]
b. 21 Oct 1904 d. 20 Jan 1994 [
=>
]
12
Margaret Woodruff
[1.1.1.1.5.3.5.4.1.11.3.3]
b. 30 Sep 1906 d. 6 Mar 1984
12
Elias Laurence Woodruff
[1.1.1.1.5.3.5.4.1.11.3.4]
b. 26 Apr 1908 d. 28 Aug 1909
12
Mildred Jennie Woodruff
[1.1.1.1.5.3.5.4.1.11.3.5]
b. 28 May 1912 d. 6 Mar 1974
11
Asahel Smith Woodruff
[1.1.1.1.5.3.5.4.1.11.4]
b. 30 Mar 1876 d. 7 Oct 1887
10
Lucy Elizabeth Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.1.12]
b. 24 Jan 1855 d. 3 Jun 1944
10
Elias Asahel Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.1.13]
b. 31 Mar 1857 d. 6 Dec 1942
10
Edith Ann Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.1.14]
b. 5 Aug 1861 d. 27 Jun 1954
9
Emily Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.2]
b. 1 Sep 1806 d. 11 Aug 1893
Samuel Pierce Hoyt
b. 21 Nov 1807 d. 12 Aug 1889
10
Cynthia Ann Hoyt
[1.1.1.1.5.3.5.4.2.1]
b. Abt 1848
10
Hyrum Hoyt
[1.1.1.1.5.3.5.4.2.2]
b. 1855
9
Jessie Johnson Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.3]
b. 6 Oct 1808 d. 1 Jul 1834
Sarah Ann Bennett
b. Abt 1808
10
Priscilla Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.3.1]
c. 26 Jul 1840
9
Esther Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.4]
b. 20 Sep 1810 d. 31 Oct 1856
Amos Botsford Fuller
b. 26 Mar 1810 d. 29 Mar 1853
10
Son Fuller
[1.1.1.1.5.3.5.4.4.1]
b. 15 May 1833 d. 15 May 1833
10
Daughter Fuller
[1.1.1.1.5.3.5.4.4.2]
b. 3 Apr 1834 d. 8 Apr 1834
10
Jesse Johnson Fuller
[1.1.1.1.5.3.5.4.4.3]
b. 1 Jun 1835 d. 31 May 1906
10
Mary Adelia Fuller
[1.1.1.1.5.3.5.4.4.4]
b. 31 Aug 1838 d. 5 Jan 1916
10
Luburn Livonia Fuller
[1.1.1.1.5.3.5.4.4.5]
b. 19 Dec 1840 d. 30 Oct 1887
10
Sophina Alcesta Fuller
[1.1.1.1.5.3.5.4.4.6]
b. 5 May 1843 d. 26 Dec 1930
George Washington Gee, Jr
b. 9 Oct 1841 d. 17 Sep 1919
11
George Washington Gee, III
[1.1.1.1.5.3.5.4.4.6.1]
b. 8 May 1864 d. 26 Mar 1865
11
Elias Amos Gee
[1.1.1.1.5.3.5.4.4.6.2]
b. 29 Jun 1868 d. 27 Apr 1936
11
Georgiana Gee
[1.1.1.1.5.3.5.4.4.6.3]
b. 15 Dec 1869 d. 5 Feb 1899
11
Mary Jane Gee
[1.1.1.1.5.3.5.4.4.6.4]
b. 8 Oct 1871 d. 16 May 1916
11
Esther Gee
[1.1.1.1.5.3.5.4.4.6.5]
b. 29 Oct 1875 d. 22 May 1942
11
Sophina Alcesta Gee
[1.1.1.1.5.3.5.4.4.6.6]
b. 6 Aug 1876 d. 17 May 1959
Joshua Robert Hodson
b. 30 Oct 1874 d. 20 Feb 1947
12
Ethelyn Hodson
[1.1.1.1.5.3.5.4.4.6.6.1]
b. 5 Apr 1903 d. 31 May 1999
12
Marva Hodson
[1.1.1.1.5.3.5.4.4.6.6.2]
b. 6 Nov 1905 d. 17 Dec 1992
12
Waldo Gee Hodson
[1.1.1.1.5.3.5.4.4.6.6.3]
b. 12 Jan 1910 d. 1 Apr 2002
12
Afton Hodson
[1.1.1.1.5.3.5.4.4.6.6.4]
b. 2 Jun 1914 d. 3 Dec 1940
12
Robert Gee Hodson
[1.1.1.1.5.3.5.4.4.6.6.5]
b. 6 Dec 1918 d. 2 Mar 1945
11
Don Carlos Gee
[1.1.1.1.5.3.5.4.4.6.7]
b. 20 Apr 1878 d. 11 Jan 1949
11
Bertha Victoria Gee
[1.1.1.1.5.3.5.4.4.6.8]
b. 31 May 1880 d. 27 Dec 1930
11
Martha Electa Gee
[1.1.1.1.5.3.5.4.4.6.9]
b. 28 Apr 1883 d. 13 May 1968
11
Adelia May Gee
[1.1.1.1.5.3.5.4.4.6.10]
b. 14 May 1885 d. 17 Feb 1964
10
Amos Botsford Fuller
[1.1.1.1.5.3.5.4.4.7]
b. 28 Sep 1846 d. 18 Aug 1879
10
Esther Victoria Fuller
[1.1.1.1.5.3.5.4.4.8]
b. 13 Jan 1848 d. 4 Sep 1857
9
Mary Jane Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.5]
b. 29 Apr 1815 d. 1 Mar 1878
George Washington Gee
b. 13 Aug 1815 d. 20 Jan 1842
10
Elias Smith Gee
[1.1.1.1.5.3.5.4.5.1]
b. 30 May 1838 d. 10 Aug 1855
10
George Washington Gee, Jr
[1.1.1.1.5.3.5.4.5.2]
b. 9 Oct 1841 d. 17 Sep 1919
Sophina Alcesta Fuller
b. 5 May 1843 d. 26 Dec 1930
11
George Washington Gee, III
[1.1.1.1.5.3.5.4.5.2.1]
b. 8 May 1864 d. 26 Mar 1865
11
Elias Amos Gee
[1.1.1.1.5.3.5.4.5.2.2]
b. 29 Jun 1868 d. 27 Apr 1936
11
Georgiana Gee
[1.1.1.1.5.3.5.4.5.2.3]
b. 15 Dec 1869 d. 5 Feb 1899
11
Mary Jane Gee
[1.1.1.1.5.3.5.4.5.2.4]
b. 8 Oct 1871 d. 16 May 1916
11
Esther Gee
[1.1.1.1.5.3.5.4.5.2.5]
b. 29 Oct 1875 d. 22 May 1942
11
Sophina Alcesta Gee
[1.1.1.1.5.3.5.4.5.2.6]
b. 6 Aug 1876 d. 17 May 1959
Joshua Robert Hodson
b. 30 Oct 1874 d. 20 Feb 1947
12
Ethelyn Hodson
[1.1.1.1.5.3.5.4.5.2.6.1]
b. 5 Apr 1903 d. 31 May 1999
12
Marva Hodson
[1.1.1.1.5.3.5.4.5.2.6.2]
b. 6 Nov 1905 d. 17 Dec 1992
12
Waldo Gee Hodson
[1.1.1.1.5.3.5.4.5.2.6.3]
b. 12 Jan 1910 d. 1 Apr 2002
12
Afton Hodson
[1.1.1.1.5.3.5.4.5.2.6.4]
b. 2 Jun 1914 d. 3 Dec 1940
12
Robert Gee Hodson
[1.1.1.1.5.3.5.4.5.2.6.5]
b. 6 Dec 1918 d. 2 Mar 1945
11
Don Carlos Gee
[1.1.1.1.5.3.5.4.5.2.7]
b. 20 Apr 1878 d. 11 Jan 1949
11
Bertha Victoria Gee
[1.1.1.1.5.3.5.4.5.2.8]
b. 31 May 1880 d. 27 Dec 1930
11
Martha Electa Gee
[1.1.1.1.5.3.5.4.5.2.9]
b. 28 Apr 1883 d. 13 May 1968
11
Adelia May Gee
[1.1.1.1.5.3.5.4.5.2.10]
b. 14 May 1885 d. 17 Feb 1964
9
Julia Priscilla Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.6]
b. 4 Mar 1815 d. 14 Aug 1906
Moses Martin
b. 1 Jun 1812 d. 5 May 1899
10
Julia Priscilla Martin
[1.1.1.1.5.3.5.4.6.1]
b. 1 Aug 1838 d. 14 Jan 1873
10
Napoleon J Martin
[1.1.1.1.5.3.5.4.6.2]
b. 1841
10
Rosella A Martin
[1.1.1.1.5.3.5.4.6.3]
b. 18 Aug 1844 d. 13 Sep 1909
10
Hiram Martin
[1.1.1.1.5.3.5.4.6.4]
b. 1 Aug 1847 d. Sep 1882
10
Joseph Martin
[1.1.1.1.5.3.5.4.6.5]
b. Abt 1850
10
Emma Cecelia Martin
[1.1.1.1.5.3.5.4.6.6]
b. Aug 1850 d. Jul 1882
10
Ada Martin
[1.1.1.1.5.3.5.4.6.7]
b. 1854
9
Silas Schellinger Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.7]
b. 6 Jun 1822 d. 11 Jun 1892
Elizabeth Orton
b. 1 Jun 1826 d. 27 Nov 1902
10
Silas Marion Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.7.1]
b. 17 Apr 1845 d. 20 Oct 1898
10
Julia Elizabeth Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.7.2]
b. 29 Jul 1848 d. 28 Oct 1878
Melvin Ross
b. 24 Sep 1842 d. 29 Nov 1920
11
Sarah Lovina Ross
[1.1.1.1.5.3.5.4.7.2.1]
b. 27 Mar 1863 d. 10 Jan 1919
11
Francis Marion Ross
[1.1.1.1.5.3.5.4.7.2.2]
b. 18 Apr 1866 d. 28 Mar 1949
11
Don Carlos Ross
[1.1.1.1.5.3.5.4.7.2.3]
b. 18 Jul 1867 d. 27 Oct 1918
11
James Melvin Ross
[1.1.1.1.5.3.5.4.7.2.4]
b. 16 Jan 1871 d. 25 Jul 1937
11
Mary Esther Ross
[1.1.1.1.5.3.5.4.7.2.5]
b. 14 Mar 1873 d. 2 Apr 1950
Hyrum Wild Stott
b. 27 Jun 1875 d. 19 Jan 1958
12
Leland Hyrum Stott
[1.1.1.1.5.3.5.4.7.2.5.1]
b. 17 Feb 1897 d. 28 Nov 1981
12
Roscoe Wild Stott
[1.1.1.1.5.3.5.4.7.2.5.2]
b. 28 Jul 1899 d. 26 May 1964
12
Asael R Stott
[1.1.1.1.5.3.5.4.7.2.5.3]
b. 23 Mar 1903 d. 21 Jun 1994
12
Percy Lynn Stott
[1.1.1.1.5.3.5.4.7.2.5.4]
b. 4 Dec 1920 d. 16 Nov 1995 [
=>
]
11
Silas Asahel Ross
[1.1.1.1.5.3.5.4.7.2.6]
b. 17 Jun 1875 d. 1895
11
Emma Ross
[1.1.1.1.5.3.5.4.7.2.7]
b. 7 Mar 1878 d. 1881
10
Frederick Asael Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.7.3]
b. 24 Jan 1850 d. 1850
10
Mary Jane Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.7.4]
b. 17 Jun 1853 d. 5 Jan 1917
John Thompson Rowley
b. 7 Nov 1847 d. 31 Jan 1925
11
John Henry Rowley
[1.1.1.1.5.3.5.4.7.4.1]
b. 10 Feb 1882 d. 14 Aug 1928
11
David Smith Rowley
[1.1.1.1.5.3.5.4.7.4.2]
b. 29 Aug 1883 d. 26 Jan 1955
11
Silas Rowley
[1.1.1.1.5.3.5.4.7.4.3]
b. 28 Oct 1885 d. 11 Oct 1949
11
Mary Ann Rowley
[1.1.1.1.5.3.5.4.7.4.4]
b. 5 Dec 1887 d. 20 Jul 1968
11
Franklin Irvin Rowley
[1.1.1.1.5.3.5.4.7.4.5]
b. 1 Jan 1890 d. 18 Jun 1951
11
Ephraim Rowley
[1.1.1.1.5.3.5.4.7.4.6]
b. 14 Oct 1893 bur. 14 Oct 1893
11
George Albert Rowley
[1.1.1.1.5.3.5.4.7.4.7]
b. 27 Nov 1894 d. 20 Jul 1976
10
Prince Henry Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.7.5]
b. 20 Oct 1858 d. 28 Nov 1922
10
Franklin D Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.7.6]
b. 29 Dec 1862 d. 16 Nov 1924
10
Vienna Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.7.7]
b. 16 Jun 1864 d. 17 Aug 1874
10
Martha Eliza Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.7.8]
b. 8 Oct 1869 d. 19 Jul 1956
Sarah Orton
b. 12 May 1830 d. 11 Dec 1912
10
Prince William Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.7.9]
b. 2 Aug 1859 d. 16 Nov 1909
10
Alexander Randolph Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.7.10]
b. 23 Dec 1861 d. 10 Sep 1865
10
David Hyrum Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.7.11]
b. 23 Dec 1863 d. 11 Mar 1865
10
Elias Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.7.12]
b. 16 May 1867 d. 18 Sep 1942
10
Sarah Esther Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.7.13]
b. 4 Nov 1869 d. 7 Nov 1869
10
Alonzo Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.7.14]
b. 5 Apr 1871 d. 24 Jan 1916
Ova Elizabeth Collins
b. 8 Aug 1879 d. 3 Jun 1960
11
Sarah Ethel Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.7.14.1]
b. 22 May 1901 d. 8 Mar 1997
+
William Edgar Johnson
b. 1897
+
Robert Neil Gladding
b. 14 Mar 1911 d. 21 Nov 1985
11
Rachel Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.7.14.2]
b. 25 Aug 1902 d. 12 May 1964
Russell John Quimby
b. 17 Apr 1892 d. 30 Apr 1979
12
Robbie Bobbie Russell Quimby
[1.1.1.1.5.3.5.4.7.14.2.1]
b. 4 Sep 1920 d. 25 Oct 1988
12
Melvin Jim Quimby
[1.1.1.1.5.3.5.4.7.14.2.2]
b. 10 Jan 1925 d. 3 Sep 2002
11
Fred Alonzo Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.7.14.3]
b. 13 Dec 1903 d. 1 Sep 1929
11
Lawrence Owen Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.7.14.4]
b. 19 Sep 1905 d. 21 Feb 1988
+
Martha Paget
b. 4 Oct 1918 d. 8 Mar 1999
11
Edith Elizabeth Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.7.14.5]
b. 25 Jan 1907 d. 31 Oct 1939
Jack Elmo Crampton
b. 6 May 1910 d. 25 Jun 1991
12
Peggy Lee Crampton
[1.1.1.1.5.3.5.4.7.14.5.1]
b. 6 Jul 1932 d. 30 Aug 2008
11
Arnold Elias Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.7.14.6]
b. 31 Oct 1910 d. 23 Jan 1976
Lavina Paget
b. 16 Apr 1916 d. 12 Feb 2013
12
Diane Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.7.14.6.1]
b. 29 Aug 1939 d. 12 Sep 1939
11
Grace Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.7.14.7]
b. 23 Feb 1913 d. 23 Nov 1997
Gordon Phillips Fraser
b. 6 Jun 1909 d. 9 Dec 1956
12
Gerald Gary Fraser
[1.1.1.1.5.3.5.4.7.14.7.1]
b. 30 Mar 1936 d. 11 Jan 2006
12
Daniel William Fraser
[1.1.1.1.5.3.5.4.7.14.7.2]
b. 13 Jul 1938 d. 19 Sep 1987
9
Martha Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.8]
b. 9 Jun 1817 d. 12 Oct 1902
Hiram Bell Bennett
b. 1 Mar 1823 d. 17 Aug 1912
10
Henry Bell Bennett
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.1]
b. Jun 1846 d. Jun 1846
10
Hyrum William Asahel Bennett
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.2]
b. 22 Nov 1848 d. 9 Jan 1849
10
Martha Eliza Bennett
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.3]
b. 24 Jan 1849 d. 6 May 1924
Silas Sanford Smith, Jr
b. 26 Oct 1830 d. 11 Oct 1910
11
Sarah Ann Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.3.1]
b. 11 Jul 1868 d. 2 Feb 1900
+
Jesse Moroni Smith
b. 21 Nov 1858 d. 14 Mar 1937
+
John Cranmer Dalton
b. 9 Jan 1857 d. 31 Aug 1906
11
Martha Eliza Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.3.2]
b. 17 Mar 1870 d. 7 Jan 1957
Thales Hastings Haskell, Jr
b. 20 Oct 1868 d. 23 Apr 1952
12
Green Dwight Haskell
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.3.2.1]
b. 8 Dec 1899 d. 25 Apr 1975 [
=>
]
12
Mark Smith Haskell
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.3.2.2]
b. 21 Apr 1901 d. 21 Feb 1958
12
Annie Haskell
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.3.2.3]
b. 10 Sep 1902 d. 11 Feb 1993 [
=>
]
12
Thales Edward Haskell
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.3.2.4]
b. 14 Oct 1904 d. 22 Dec 1982 [
=>
]
12
Hattie Haskell
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.3.2.5]
b. 3 Oct 1907 d. 1 Jan 1963
11
Curtis Bennett Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.3.3]
b. 23 Oct 1871 d. 28 Nov 1942
+
Ursula Pearl Harrison
b. 25 Jul 1879 d. 10 Nov 1960
11
Elias Austin Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.3.4]
b. 4 Mar 1874 d. 27 Jun 1925
Jessie Arlettia Block
b. 20 Feb 1879 d. 22 Apr 1958
12
Eva Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.3.4.1]
b. 8 Jun 1899 d. 22 Aug 1979 [
=>
]
12
Austin Block Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.3.4.2]
b. 26 Dec 1900 d. 1 Aug 1976 [
=>
]
12
Elias Penn Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.3.4.3]
b. 1 Oct 1902 d. 1 Feb 1976
12
Mack Bennett Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.3.4.4]
b. 23 Nov 1905 d. 1975 [
=>
]
12
Rex Poulson Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.3.4.5]
b. 3 Nov 1910 d. 22 Mar 1925
12
Amy Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.3.4.6]
b. 26 Sep 1913 d. 20 Mar 1994 [
=>
]
11
Emma Jane Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.3.5]
b. 4 Apr 1876 d. 16 Jan 1951
Edwin Cleveland Dibble
b. 1 Sep 1869 d. 28 Jan 1947
12
Edwin Smith Dibble
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.3.5.1]
b. 5 Dec 1901 d. 12 Sep 2003
12
George Smith Dibble
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.3.5.2]
b. 29 Mar 1904 d. 1 Jun 1992
12
Joseph Smith Dibble
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.3.5.3]
b. 6 Jun 1907 d. 17 Sep 1973 [
=>
]
12
Asael Smith Dibble
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.3.5.4]
b. 31 Jul 1910 d. 16 Dec 2000 [
=>
]
12
Verlie Dibble
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.3.5.5]
b. 25 Nov 1917 d. 19 Sep 1985
11
George Essex Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.3.6]
b. 24 Sep 1878 d. 26 May 1949
Vista May Rogers
b. 27 Aug 1880 d. 27 Jun 1954
12
May Rhue Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.3.6.1]
b. 8 Nov 1902 d. 6 Jul 1989
12
George Essex Smith, Jr
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.3.6.2]
b. 5 Aug 1904 d. 20 Jan 1985
12
Margaret Eliza Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.3.6.3]
b. 17 May 1906 d. 6 May 1996
12
Silas Bennett Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.3.6.4]
b. 16 Jan 1908 d. 27 Jan 1908
12
Sanford Snow Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.3.6.5]
b. 20 Feb 1911 d. 6 Dec 1928
12
Martha Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.3.6.6]
b. 20 Aug 1915 d. 21 Nov 1915
12
Milton Ralph Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.3.6.7]
b. 26 Oct 1918 d. 13 Aug 1986
11
Erastus Snow Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.3.7]
b. 18 Aug 1881 d. 16 Sep 1890
11
Hyrum Asahel Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.3.8]
b. 15 Sep 1883 d. 16 Jul 1941
Rebecca Pearl Hodson
b. 26 Oct 1883 d. 17 Oct 1965
12
Inez Myrtle Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.3.8.1]
b. 17 Nov 1905 d. 1 Aug 1994
12
Asahel Earl Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.3.8.2]
b. 29 Mar 1910 d. 3 Jan 1969 [
=>
]
12
Annie Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.3.8.3]
b. 24 Nov 1912 d. 23 Feb 1913
12
Fay Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.3.8.4]
b. 18 Feb 1915 d. 9 Jan 2000
12
Donald Hodson Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.3.8.5]
b. 19 May 1923 d. 12 Aug 1943
11
Lucy Edith Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.3.9]
b. 12 Aug 1886 d. 6 Jan 1963
David DuBois Dibble
b. 13 Sep 1876 d. 24 Apr 1975
12
Frances Dibble
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.3.9.1]
b. 18 Dec 1923 d. 16 Sep 1990 [
=>
]
12
David Smith Dibble
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.3.9.2]
b. 2 Apr 1928 d. 27 Dec 1993 [
=>
]
11
Joseph Frances Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.3.10]
b. 7 Apr 1889 d. 14 Feb 1920
Lavinia Ann Webster
b. 2 Mar 1890 d. 29 Nov 1962
12
Verlie W Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.3.10.1]
b. 14 Oct 1915 d. 17 Feb 2001 [
=>
]
12
Francis Bennett Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.3.10.2]
b. 29 Oct 1917 d. 12 Apr 1978
12
Arthur Agle Millecan
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.3.10.3]
b. 30 Jul 1922 d. 10 Apr 2003 [
=>
]
11
Clara Estella Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.3.11]
b. 4 Aug 1891 d. 10 May 1992
11
Verlie Dorcas Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.3.12]
b. 14 Oct 1894 d. 23 Dec 1894
10
Ezra Melanthorn Bennett
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.4]
b. 20 Oct 1851 d. 25 Aug 1852
10
Emily Jane Bennett
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.5]
b. 17 Jan 1854 d. 4 May 1903
John Aikens Smith
b. 19 Mar 1854 d. 9 Jan 1923
11
Emily Jane Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.5.1]
b. 5 May 1878 d. 21 Feb 1958
Levi Dunn
b. 9 Jan 1880 d. 9 Feb 1968
12
Emily Dunn
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.5.1.1]
b. 27 Mar 1911 d. 15 Jan 1988 [
=>
]
12
Alton Smith Dunn
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.5.1.2]
b. 19 Feb 1914 d. 6 Oct 1976
12
Leon Bennett Dunn
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.5.1.3]
b. 15 May 1916 d. 17 Feb 1975
12
Marcel Harmon Dunn
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.5.1.4]
b. 12 Jan 1919 d. 24 Aug 2002
11
Sarah Ann Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.5.2]
b. 23 Apr 1883 d. 22 Feb 1969
Joseph Beharm DePriest
b. 27 Jan 1881 d. 15 May 1969
12
Emily Lenella DePriest
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.5.2.1]
b. 22 Oct 1909 d. 17 Nov 1990
12
Lucy DePriest
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.5.2.2]
b. 29 Jun 1913 d. 4 Jan 1986 [
=>
]
12
Clarice DePriest
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.5.2.3]
b. 25 Dec 1915 d. 23 Oct 1999
12
Joseph Smith DePriest
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.5.2.4]
b. 21 Jul 1921 d. 5 Aug 1946 [
=>
]
11
Mary Hortense Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.5.3]
b. 19 Dec 1884 d. 8 Jun 1885
11
Martha Eliza Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.5.4]
b. 23 Aug 1886 d. 2 Apr 1980
David Earl Shawcroft
b. 17 Jun 1887 d. 25 Nov 1969
12
Zina Shawcroft
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.5.4.1]
b. 9 Mar 1913 d. 17 Jun 1916
12
Alice Shawcroft
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.5.4.2]
b. 11 Nov 1914 d. 4 Dec 2001 [
=>
]
12
David Amel Shawcroft
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.5.4.3]
b. 11 Dec 1916 d. 22 Feb 1944
12
Hazel Shawcroft
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.5.4.4]
b. 12 Nov 1918 d. 16 May 1964 [
=>
]
12
Earl Smith Shawcroft
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.5.4.5]
b. 6 Oct 1920 d. 27 Feb 2001 [
=>
]
12
Lucy Elizabeth Shawcroft
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.5.4.6]
b. 28 Jan 1923 d. 5 Jan 1926
12
John Bennett Shawcroft
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.5.4.7]
b. 26 Mar 1925 d. 29 Feb 2012 [
=>
]
11
John Aikens Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.5.5]
b. 5 Oct 1888 d. 4 Apr 1970
Ione Decker
b. 16 Aug 1890 d. 30 Dec 1963
12
Emma Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.5.5.1]
b. 9 Apr 1913 d. 7 Jan 2004
12
Majorie Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.5.5.2]
b. 6 Mar 1915 d. 8 May 1915
12
Majel Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.5.5.3]
b. 13 Feb 1918 d. 30 Nov 1997
12
John Decker Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.5.5.4]
b. 26 May 1920 d. 1 Jun 2002
12
Morris Montell Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.5.5.5]
b. 8 Oct 1924 d. 28 Jan 2007
+
Effie Elizabeth Pruitt Nokes
b. 18 Sep 1897 d. 25 Dec 1996
11
Lucy Elizabeth Smith
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.5.6]
b. 24 May 1893 d. 23 Oct 1944
10
Elizabeth Emma Bennett
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.6]
b. 2 Jul 1856 d. 26 Feb 1940
Joseph Henry Fisher
b. 18 Oct 1856 d. 21 Nov 1940
11
Zina Elizabeth Fisher
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.6.1]
b. 6 Nov 1880 d. 14 Feb 1890
11
Martha Hannah Lees Fisher
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.6.2]
b. 19 Feb 1882 d. 23 May 1958
John Delbert Bushnell
b. 26 May 1883 d. 7 Apr 1975
12
Kelleth Delbert Bushnell
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.6.2.1]
b. 12 Feb 1908 d. 21 Aug 1983 [
=>
]
12
Wanda Bushnell
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.6.2.2]
b. 22 Feb 1909 d. 28 Oct 2002 [
=>
]
12
Joseph Avon Bushnell
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.6.2.3]
b. 21 Apr 1910 d. 4 Jun 1988 [
=>
]
12
Linda Bushnell
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.6.2.4]
b. 23 Nov 1912 d. 25 May 2001 [
=>
]
12
Elizabeth Bushnell
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.6.2.5]
b. 11 Nov 1923 d. 27 Apr 1970
11
Mary Emily Fisher
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.6.3]
b. 25 Oct 1883 d. 18 Feb 1890
11
Joseph Lees Fisher
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.6.4]
b. 5 Oct 1885 d. 14 Feb 1890
11
Albert Hyrum Fisher
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.6.5]
b. 28 Dec 1888 d. 10 Jul 1973
Alta Jane Beckstrand
b. 18 Aug 1894 d. 8 Dec 1973
12
Lela Fisher
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.6.5.1]
b. 9 Aug 1917 d. 10 Mar 1920
12
Carol Fisher
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.6.5.2]
b. 7 Nov 1919 d. 31 Jul 2009 [
=>
]
12
Wanda Fisher
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.6.5.3]
b. 20 Jan 1922 d. 21 Sep 2007 [
=>
]
12
Living
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.6.5.4]
12
Beulah Fisher
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.6.5.5]
b. 27 Apr 1929 d. 8 Dec 2017 [
=>
]
12
Living
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.6.5.6]
11
Angie Celestine Fisher
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.6.6]
b. 2 May 1893 d. 25 Nov 1971
William Connell
b. 4 Jan 1888 d. 28 Mar 1976
12
Maxine Connell
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.6.6.1]
b. 21 Jan 1916 d. 1 Jan 2012
12
Beth Connell
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.6.6.2]
b. 1 Nov 1919 d. 16 Aug 1995
11
James Clyde Fisher
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.6.7]
b. 5 Jun 1896 d. 19 Nov 1977
+
Mabel Alice Bushnell
b. 15 May 1900 d. 2 Jun 1924
+
Giovanna Maria Botero
b. 2 Aug 1891 d. 8 Oct 1976
11
Cecil Neil Fisher
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.6.8]
b. 8 Jul 1898 d. 2 Oct 1983
Thelma Beckstrand
b. 23 Sep 1900 d. 19 Apr 1982
12
Cecil Fisher
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.6.8.1]
12
Jay Neil Fisher
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.6.8.2]
b. 1 Mar 1920 d. 13 Nov 2011 [
=>
]
12
Ione Fisher
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.6.8.3]
b. 13 Jul 1923 d. 18 Sep 2006 [
=>
]
10
Elias Austin Bennett
[1.1.1.1.5.3.5.4.8.7]
b. 26 Jan 1858 d. 1 May 1861
+
Jane Smith
b. 1775
8
Mary Smith
[1.1.1.1.5.3.5.5]
b. 4 Jun 1775 d. 24 May 1844
Isaac Pierce
b. 11 Oct 1773 d. 9 Nov 1847
9
Eunice Pierce
[1.1.1.1.5.3.5.5.1]
b. 29 Apr 1799 d. 9 Jun 1803
9
Laura Pierce
[1.1.1.1.5.3.5.5.2]
b. 12 Nov 1801 d. 1803
9
Miranda Pierce
[1.1.1.1.5.3.5.5.3]
b. 17 Jun 1803 d. 16 Sep 1831
9
Horace Pierce
[1.1.1.1.5.3.5.5.4]
b. 8 Jun 1805 d. 20 May 1877
9
John S. Pierce
[1.1.1.1.5.3.5.5.5]
b. 6 Jun 1807 d. 3 Apr 1854
9
Susan Pierce
[1.1.1.1.5.3.5.5.6]
b. 20 Jun 1809 d. 4 Apr 1855
9
Mary Pierce
[1.1.1.1.5.3.5.5.7]
b. 25 Apr 1811
9
Elisabeth Ann Pierce
[1.1.1.1.5.3.5.5.8]
b. 2 Sep 1817 d. 16 May 1855
+
Joseph Brimhall
b. 1771
+
Charles Smith
b. 1772
8
Samuel Smith
[1.1.1.1.5.3.5.6]
b. 15 Sep 1777 d. 1 Apr 1830
Frances Wilcox
b. 1780
9
Charles Smith
[1.1.1.1.5.3.5.6.1]
b. 16 Apr 1817
9
Laura Smith
[1.1.1.1.5.3.5.6.2]
b. 1 Mar 1819
9
Horace Jay Smith
[1.1.1.1.5.3.5.6.3]
b. 12 Jul 1821
9
Sarah Smith
[1.1.1.1.5.3.5.6.4]
b. 11 Jun 1824
9
Elizabeth Smith
[1.1.1.1.5.3.5.6.5]
b. 16 Jul 1826
8
Silas Sanford Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7]
b. 1 Oct 1779 d. 13 Sep 1839
Ruth Steven
b. 1782 d. 10 Jan 1864
9
Charles Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.1]
b. 11 Nov 1806 d. 7 May 1809
9
Charity Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.2]
b. 1 Apr 1808 d. 2 Jun 1888
+
Richard Smith
b. 1808
9
Curtis Stevens Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.3]
b. 29 Oct 1809 d. 23 Sep 1861
Celia Euphrasia Ross
b. 1829 d. 28 Jun 1857
10
Ezra Ross Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.3.1]
b. 24 Jul 1852 d. 17 May 1853
10
William Curtis Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.3.2]
b. 14 Apr 1857 d. 1 Mar 1945
9
Samuel Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.4]
b. 3 Oct 1811 d. 7 Mar 1826
9
Stephen Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.5]
b. 8 Jan 1815 d. 20 Feb 1891
9
Susan Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.6]
b. 19 Oct 1817 d. 20 Nov 1846
9
Asahel Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.7]
b. 12 Oct 1819 d. 15 May 1834
Mary Aikens
b. 13 Aug 1797 d. 27 Apr 1877
9
Silas Sanford Smith, Jr
[1.1.1.1.5.3.5.7.8]
b. 26 Oct 1830 d. 11 Oct 1910
Martha Eliza Bennett
b. 24 Jan 1849 d. 6 May 1924
10
Sarah Ann Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.1]
b. 11 Jul 1868 d. 2 Feb 1900
+
Jesse Moroni Smith
b. 21 Nov 1858 d. 14 Mar 1937
+
John Cranmer Dalton
b. 9 Jan 1857 d. 31 Aug 1906
10
Martha Eliza Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.2]
b. 17 Mar 1870 d. 7 Jan 1957
Thales Hastings Haskell, Jr
b. 20 Oct 1868 d. 23 Apr 1952
11
Green Dwight Haskell
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.2.1]
b. 8 Dec 1899 d. 25 Apr 1975
Lena Opal Richardson
b. 5 Oct 1905 d. 24 Sep 1990
12
Dwight Richardson Haskell
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.2.1.1]
b. 12 Nov 1926 d. 20 Dec 2012
11
Mark Smith Haskell
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.2.2]
b. 21 Apr 1901 d. 21 Feb 1958
+
Mary Louise Jensen
b. 27 Jan 1906 d. 27 Apr 1971
11
Annie Haskell
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.2.3]
b. 10 Sep 1902 d. 11 Feb 1993
Weir Ferguson Smith
b. 6 May 1901 d. 5 Mar 1988
12
Ross Kelvin Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.2.3.1]
b. 28 Jun 1931 d. 24 Jun 1994
12
Jo Anne Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.2.3.2]
b. 29 Jan 1935 d. 22 Jan 2003 [
=>
]
11
Thales Edward Haskell
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.2.4]
b. 14 Oct 1904 d. 22 Dec 1982
Edith Olson
b. 20 Oct 1902 d. 16 Dec 1980
12
Maralyne Haskell
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.2.4.1]
b. 23 Jun 1928 d. 5 Jun 2012 [
=>
]
11
Hattie Haskell
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.2.5]
b. 3 Oct 1907 d. 1 Jan 1963
+
Milton Hicks
b. 25 Oct 1915 d. 17 Mar 1983
10
Curtis Bennett Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.3]
b. 23 Oct 1871 d. 28 Nov 1942
+
Ursula Pearl Harrison
b. 25 Jul 1879 d. 10 Nov 1960
10
Elias Austin Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.4]
b. 4 Mar 1874 d. 27 Jun 1925
Jessie Arlettia Block
b. 20 Feb 1879 d. 22 Apr 1958
11
Eva Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.4.1]
b. 8 Jun 1899 d. 22 Aug 1979
Cecil Gee Sumner
b. 14 Aug 1905 d. 1 Apr 1991
12
Eve Smith Sumner
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.4.1.1]
b. 24 Jul 1935 d. 27 Sep 1972
11
Austin Block Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.4.2]
b. 26 Dec 1900 d. 1 Aug 1976
Helen Taggart
b. 29 Jul 1911 d. 22 Jul 2003
12
Austin Taggart Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.4.2.1]
b. 28 Nov 1938 d. 30 Oct 1987
11
Elias Penn Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.4.3]
b. 1 Oct 1902 d. 1 Feb 1976
+
Louise Harris
b. 25 Apr 1902 d. 28 Nov 1955
11
Mack Bennett Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.4.4]
b. 23 Nov 1905 d. 1975
Marion Eveline Jensen
b. 12 Apr 1908 d. 16 Sep 1979
12
Debra Annette Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.4.4.1]
b. 15 Dec 1951 d. 19 Apr 1987
11
Rex Poulson Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.4.5]
b. 3 Nov 1910 d. 22 Mar 1925
11
Amy Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.4.6]
b. 26 Sep 1913 d. 20 Mar 1994
Howard Eugene Baysinger
b. 23 Aug 1912 d. Nov 1978
12
Austin Smith Baysinger
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.4.6.1]
b. 26 Feb 1947 d. 10 Jan 2009
10
Emma Jane Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.5]
b. 4 Apr 1876 d. 16 Jan 1951
Edwin Cleveland Dibble
b. 1 Sep 1869 d. 28 Jan 1947
11
Edwin Smith Dibble
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.5.1]
b. 5 Dec 1901 d. 12 Sep 2003
+
Ruth Emily Gollaher
b. 9 Sep 1905 d. 26 Nov 1985
11
George Smith Dibble
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.5.2]
b. 29 Mar 1904 d. 1 Jun 1992
+
Cleone Atwood
b. 6 Jul 1908 d. 25 Nov 1990
11
Joseph Smith Dibble
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.5.3]
b. 6 Jun 1907 d. 17 Sep 1973
Blanche Woodruff McEwan
b. 6 Apr 1915 d. 23 Jun 1985
12
Elizabeth Jo Dibble
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.5.3.1]
b. 21 Apr 1937 d. 15 Feb 1970
11
Asael Smith Dibble
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.5.4]
b. 31 Jul 1910 d. 16 Dec 2000
Claire Fisher
b. 2 Dec 1913 d. 18 Mar 1993
12
Living
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.5.4.1]
11
Verlie Dibble
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.5.5]
b. 25 Nov 1917 d. 19 Sep 1985
+
Clyde Fielding Smith
b. 11 Oct 1903 d. 6 Dec 1980
10
George Essex Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.6]
b. 24 Sep 1878 d. 26 May 1949
Vista May Rogers
b. 27 Aug 1880 d. 27 Jun 1954
11
May Rhue Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.6.1]
b. 8 Nov 1902 d. 6 Jul 1989
+
William Milton Holmes
b. 12 Oct 1904 d. 19 Jan 1987
11
George Essex Smith, Jr
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.6.2]
b. 5 Aug 1904 d. 20 Jan 1985
+
Cella King
b. 6 Feb 1907 d. 8 Feb 1980
+
Laura Verina Crowther
b. 25 Nov 1903 d. 14 Jul 1989
11
Margaret Eliza Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.6.3]
b. 17 May 1906 d. 6 May 1996
+
Charles Frederick Chapman
b. 16 Oct 1898 d. 23 Nov 1969
11
Silas Bennett Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.6.4]
b. 16 Jan 1908 d. 27 Jan 1908
11
Sanford Snow Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.6.5]
b. 20 Feb 1911 d. 6 Dec 1928
11
Martha Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.6.6]
b. 20 Aug 1915 d. 21 Nov 1915
11
Milton Ralph Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.6.7]
b. 26 Oct 1918 d. 13 Aug 1986
+
Carol Rose Hiatt
b. 30 Aug 1921 d. 22 Sep 2002
10
Erastus Snow Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.7]
b. 18 Aug 1881 d. 16 Sep 1890
10
Hyrum Asahel Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.8]
b. 15 Sep 1883 d. 16 Jul 1941
Rebecca Pearl Hodson
b. 26 Oct 1883 d. 17 Oct 1965
11
Inez Myrtle Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.8.1]
b. 17 Nov 1905 d. 1 Aug 1994
+
William Uffo Uffens
b. 14 Jan 1908 d. 7 Mar 1997
11
Asahel Earl Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.8.2]
b. 29 Mar 1910 d. 3 Jan 1969
Nora Ann Porter
b. 11 Jul 1908 d. 16 Jun 1992
12
Donald Porter Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.8.2.1]
b. 3 Apr 1949 d. 4 Jul 2011
11
Annie Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.8.3]
b. 24 Nov 1912 d. 23 Feb 1913
11
Fay Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.8.4]
b. 18 Feb 1915 d. 9 Jan 2000
+
Woodrow Mitchell Lewis
b. 24 Feb 1914 d. 1 Aug 1984
11
Donald Hodson Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.8.5]
b. 19 May 1923 d. 12 Aug 1943
10
Lucy Edith Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.9]
b. 12 Aug 1886 d. 6 Jan 1963
David DuBois Dibble
b. 13 Sep 1876 d. 24 Apr 1975
11
Frances Dibble
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.9.1]
b. 18 Dec 1923 d. 16 Sep 1990
Scott Monroe McKay
b. 6 Sep 1921 d. 14 Mar 1983
12
Frances Ann McKay
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.9.1.1]
b. 28 Jul 1953 d. 18 Nov 2006
12
Living
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.9.1.2]
12
Donald David McKay
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.9.1.3]
b. 6 Apr 1956 d. 30 May 1956
+
Charles Dorsey Warren
b. 15 May 1905 d. 23 Dec 1983
11
David Smith Dibble
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.9.2]
b. 2 Apr 1928 d. 27 Dec 1993
12
Ann Dibble
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.9.2.1]
b. 13 Nov 1951 d. 30 May 2008
10
Joseph Frances Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.10]
b. 7 Apr 1889 d. 14 Feb 1920
Lavinia Ann Webster
b. 2 Mar 1890 d. 29 Nov 1962
11
Verlie W Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.10.1]
b. 14 Oct 1915 d. 17 Feb 2001
Gordon Beard Taylor
b. 3 May 1914 d. 16 Dec 2001
12
Roma Diane Taylor
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.10.1.1]
b. 21 Dec 1937 d. 24 Dec 1937
11
Francis Bennett Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.10.2]
b. 29 Oct 1917 d. 12 Apr 1978
+
Alice M Hummel
b. 1909
11
Arthur Agle Millecan
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.10.3]
b. 30 Jul 1922 d. 10 Apr 2003
Betty Margaret Stoddard
b. 15 Dec 1921 d. 21 Oct 2012
12
Arthur Stoddard Millecan
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.10.3.1]
b. 17 Jun 1961 d. 18 Jun 1961
10
Clara Estella Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.11]
b. 4 Aug 1891 d. 10 May 1992
10
Verlie Dorcas Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.12]
b. 14 Oct 1894 d. 23 Dec 1894
Clarinda Rich
b. 10 Jan 1835 d. 18 Mar 1864
10
Silas Sanford Smith, Jr
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.13]
b. 10 Jul 1853 d. 19 Jan 1911
10
Jesse Joel Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.14]
b. 4 Nov 1857 d. 12 Sep 1905
10
Leonora Abigail Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.15]
b. 22 Oct 1859 d. 26 Sep 1863
10
Stephen Augustus Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.16]
b. 1 Nov 1861 d. 21 Oct 1939
10
Ella Clarinda Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.17]
b. 9 Mar 1864 d. 2 Jun 1913
Sally Ann Ricks
b. 28 Dec 1832 d. 30 Jun 1864
10
John Aikens Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.18]
b. 19 Mar 1854 d. 9 Jan 1923
Emily Jane Bennett
b. 17 Jan 1854 d. 4 May 1903
11
Emily Jane Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.18.1]
b. 5 May 1878 d. 21 Feb 1958
Levi Dunn
b. 9 Jan 1880 d. 9 Feb 1968
12
Emily Dunn
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.18.1.1]
b. 27 Mar 1911 d. 15 Jan 1988 [
=>
]
12
Alton Smith Dunn
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.18.1.2]
b. 19 Feb 1914 d. 6 Oct 1976
12
Leon Bennett Dunn
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.18.1.3]
b. 15 May 1916 d. 17 Feb 1975
12
Marcel Harmon Dunn
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.18.1.4]
b. 12 Jan 1919 d. 24 Aug 2002
11
Sarah Ann Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.18.2]
b. 23 Apr 1883 d. 22 Feb 1969
Joseph Beharm DePriest
b. 27 Jan 1881 d. 15 May 1969
12
Emily Lenella DePriest
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.18.2.1]
b. 22 Oct 1909 d. 17 Nov 1990
12
Lucy DePriest
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.18.2.2]
b. 29 Jun 1913 d. 4 Jan 1986 [
=>
]
12
Clarice DePriest
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.18.2.3]
b. 25 Dec 1915 d. 23 Oct 1999
12
Joseph Smith DePriest
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.18.2.4]
b. 21 Jul 1921 d. 5 Aug 1946 [
=>
]
11
Mary Hortense Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.18.3]
b. 19 Dec 1884 d. 8 Jun 1885
11
Martha Eliza Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.18.4]
b. 23 Aug 1886 d. 2 Apr 1980
David Earl Shawcroft
b. 17 Jun 1887 d. 25 Nov 1969
12
Zina Shawcroft
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.18.4.1]
b. 9 Mar 1913 d. 17 Jun 1916
12
Alice Shawcroft
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.18.4.2]
b. 11 Nov 1914 d. 4 Dec 2001 [
=>
]
12
David Amel Shawcroft
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.18.4.3]
b. 11 Dec 1916 d. 22 Feb 1944
12
Hazel Shawcroft
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.18.4.4]
b. 12 Nov 1918 d. 16 May 1964 [
=>
]
12
Earl Smith Shawcroft
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.18.4.5]
b. 6 Oct 1920 d. 27 Feb 2001 [
=>
]
12
Lucy Elizabeth Shawcroft
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.18.4.6]
b. 28 Jan 1923 d. 5 Jan 1926
12
John Bennett Shawcroft
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.18.4.7]
b. 26 Mar 1925 d. 29 Feb 2012 [
=>
]
11
John Aikens Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.18.5]
b. 5 Oct 1888 d. 4 Apr 1970
Ione Decker
b. 16 Aug 1890 d. 30 Dec 1963
12
Emma Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.18.5.1]
b. 9 Apr 1913 d. 7 Jan 2004
12
Majorie Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.18.5.2]
b. 6 Mar 1915 d. 8 May 1915
12
Majel Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.18.5.3]
b. 13 Feb 1918 d. 30 Nov 1997
12
John Decker Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.18.5.4]
b. 26 May 1920 d. 1 Jun 2002
12
Morris Montell Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.18.5.5]
b. 8 Oct 1924 d. 28 Jan 2007
+
Effie Elizabeth Pruitt Nokes
b. 18 Sep 1897 d. 25 Dec 1996
11
Lucy Elizabeth Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.18.6]
b. 24 May 1893 d. 23 Oct 1944
10
Mary Eleanor Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.19]
b. 26 Sep 1857 d. 25 Nov 1888
10
Hortense Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.20]
b. 14 Oct 1859 d. 8 Sep 1945
10
Albert Ricks Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.21]
b. 1 Apr 1862 d. 17 May 1905
10
Hyrum Barton Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.8.22]
b. 16 Jun 1864 d. 9 Aug 1864
9
John Aikens Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.9]
b. 6 Jul 1832 d. 27 Nov 1838
9
Jesse Nathaniel Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.10]
b. 2 Dec 1834 d. 5 Jun 1906
Augusta Maria Outzen
b. 14 Jan 1854 d. 26 Apr 1932
10
Georgianna Bathsheba Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.1]
b. 16 Aug 1870 d. 14 May 1946
10
Augusta Gerhardina "Dina" Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.2]
b. 14 Jul 1872 d. 9 Jan 1940
10
Robert Christian Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.3]
b. 27 Nov 1874 d. 9 Apr 1920
10
Martha Amelia Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.4]
b. 17 Jul 1877 d. 10 Aug 1931
James Madison Flake
b. 8 Nov 1859 d. 4 Feb 1946
11
Donald Christian Flake
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.4.1]
b. 24 Oct 1897 d. 4 Jan 1979
11
Augusta Flake
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.4.2]
b. 4 Mar 1899 d. 1 Jun 1993
11
Silas Eugene Flake
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.4.3]
b. 9 Sep 1900 d. 19 Dec 1983
+
Ruth Whipple
b. 27 Dec 1910 d. 16 Sep 1994
11
Virgil Maeser Flake
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.4.4]
b. 24 Feb 1902 d. 19 Jan 1966
11
Joseph Marion Flake
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.4.5]
b. 8 Oct 1903 d. 24 Jan 1982
11
Thelma Flake
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.4.6]
b. 3 Jul 1905 d. 7 Dec 1923
11
Bruce Merlin Flake
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.4.7]
b. 27 Jan 1907 d. 10 May 1971
11
Vernon Smith Flake
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.4.8]
b. 23 Dec 1908 d. 15 Sep 1965
11
Mary Flake
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.4.9]
b. 10 Aug 1910 d. 27 Aug 1910
11
Anna Flake
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.4.10]
b. 24 Sep 1911 d. 20 Mar 2000
11
Ruth Flake
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.4.11]
b. 23 Nov 1913 d. 6 Jun 1975
11
Vincent Madison Flake
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.4.12]
b. 19 Jul 1915 d. 19 Aug 1988
11
Aften Flake
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.4.13]
b. 8 Aug 1916 d. 1 Oct 2008
11
Fost Wilson Flake
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.4.14]
b. 12 Mar 1918 d. 31 Aug 1997
10
Asahel Henry Smith, Sr
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.5]
b. 5 Dec 1880 d. 7 Sep 1947
10
Anna Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.6]
b. 6 Aug 1883 d. 8 Oct 1910
10
Rebecca Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.7]
b. 23 Oct 1886 d. 3 Nov 1960
10
Rachel Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.8]
b. 1 Jan 1889 d. 13 Jul 1940
10
Sophronia Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.9]
b. 8 Apr 1892 d. 11 Oct 1953
10
Natalia Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.10]
b. 3 Apr 1894 d. 2 Jun 1978
10
Millie Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.11]
b. 25 Dec 1897 d. 3 Oct 1931
Emma Seraphine West
b. 3 Jan 1836 d. 15 Oct 1910
10
Emma Seraphine Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.12]
b. 12 Aug 1853 d. 29 Dec 1909
10
Mary Josephine Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.13]
b. 23 Jan 1855 d. 17 Dec 1894
10
Hannah Daphne Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.14]
b. 22 Mar 1857 d. 10 May 1937
10
Eliza Snow Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.15]
b. 23 Feb 1859 d. 27 Dec 1927
10
Jesse Nathaniel Smith, Jr
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.16]
b. 16 May 1861 d. 13 Jul 1912
10
Sarah Elizabeth Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.17]
b. 2 Feb 1866 d. 15 Sep 1892
10
Silas Derryfield Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.18]
b. 9 Sep 1867 d. 26 Feb 1956
10
John Walter Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.19]
b. 10 Jun 1871 d. 7 May 1936
10
Samuel Francis Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.20]
b. 21 Nov 1873 d. 24 Jan 1954
Margaret Fletcher West
b. 22 May 1838 d. 1 Feb 1864
10
Adelaide Margaret Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.21]
b. 13 Feb 1857 d. 29 Oct 1927
10
Joseph West Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.22]
b. 6 Sep 1859 d. 22 Dec 1944
Janet Mauretta Johnson
b. 17 Dec 1848 d. 21 May 1933
10
Susan Janet Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.23]
b. 15 Sep 1868 d. 15 Dec 1960
Heber Jarvis
b. 14 Oct 1860 d. 8 Oct 1953
11
Heber Jarvis, Jr
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.23.1]
b. 15 Apr 1885 d. 26 Mar 1886
11
Jesse Rulon Jarvis
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.23.2]
b. 13 Jun 1886 d. 10 Jun 1960
Harriet Whipple
b. 23 Mar 1890 d. 24 Mar 1956
12
Jesse Rulon Jarvis, Jr
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.23.2.1]
b. 27 May 1909 d. 24 Jun 1990 [
=>
]
12
Marvin Earl Jarvis
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.23.2.2]
b. 24 Nov 1910 d. 26 Jan 1991 [
=>
]
12
Oliver Temple Jarvis
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.23.2.3]
b. 13 Feb 1913 d. 5 Aug 1914
12
Edith Jarvis
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.23.2.4]
b. 1 Jan 1915 d. 16 Nov 1979 [
=>
]
12
Grant Stanley Jarvis
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.23.2.5]
b. 31 Jan 1918 d. 14 May 1923
12
Erma Jarvis
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.23.2.6]
b. 21 Jul 1920 d. 23 Feb 1922
12
Eva Jarvis
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.23.2.7]
b. 6 Feb 1922 d. 26 Feb 1933
12
Rex Whipple Jarvis
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.23.2.8]
b. 27 Jan 1924 d. 12 Mar 1933
12
Wayne Heber Jarvis
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.23.2.9]
b. 14 Sep 1927 d. 1 May 1931
12
Joy Smith Jarvis
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.23.2.10]
b. 24 Feb 1930 d. 19 Sep 1930
11
Maude Jarvis
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.23.3]
b. 26 Jan 1888 d. 14 Mar 1974
11
George Jarvis
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.23.4]
b. 21 Mar 1889 d. 28 Aug 1981
11
Janet Jarvis
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.23.5]
b. 10 Feb 1891 d. 20 Oct 1944
11
Annie Jarvis
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.23.6]
b. 22 Apr 1892 d. 5 Apr 1893
11
Joseph Smith Jarvis
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.23.7]
b. 6 Mar 1894 d. 12 Jun 1989
11
Pearl Jarvis
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.23.8]
b. 7 Aug 1896 d. 12 Dec 1983
11
William Prior Jarvis
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.23.9]
b. 22 Sep 1898 d. 17 Mar 1973
11
Susie Jarvis
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.23.10]
b. 1 May 1901 d. 18 May 1929
11
Thomas Earl Jarvis
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.23.11]
b. 25 Apr 1903 d. 17 Apr 1906
11
Silas Fielding Jarvis
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.23.12]
b. 28 Feb 1905 d. 19 Oct 1983
11
Margaret Jarvis
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.23.13]
b. 1 Oct 1906 d. 19 Mar 1994
11
Ethel Jarvis
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.23.14]
b. 18 Oct 1908 d. 13 Sep 2006
11
Rudger LaVerl Jarvis
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.23.15]
b. 15 May 1911 d. 29 Jun 2002
10
Ellen Mauretta Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.24]
b. 20 Sep 1871 d. 1 Aug 1872
10
Sariah Anna Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.25]
b. 21 Feb 1873 d. 26 Dec 1922
10
Agnes Maud Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.26]
b. 11 Jul 1874 d. 7 Oct 1878
10
Julia Johnson Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.27]
b. 20 Oct 1875 d. 27 Apr 1956
10
Priscilla Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.28]
b. 10 May 1877 d. 17 Jan 1954
10
Editha Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.29]
b. 8 Sep 1878 d. 28 Jul 1931
10
Lucy Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.30]
b. 24 Jun 1880 d. 15 Nov 1951
William Howard Shumway
b. 20 Jul 1877 d. 20 Jun 1945
11
Donnetta Shumway
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.30.1]
b. 27 Oct 1899 d. 9 Jan 1955
11
Howard Burton Shumway
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.30.2]
b. 5 Mar 1901 d. 21 Jul 1933
11
Priscilla Shumway
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.30.3]
b. 2 Mar 1903 d. 15 Jan 1992
11
Kenneth Smith Shumway
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.30.4]
b. 13 Feb 1905 d. 10 Oct 1972
11
Charles Richard Shumway
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.30.5]
b. 12 Aug 1907 d. 17 Dec 1990
11
Elizabeth Shumway
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.30.6]
b. 25 Jan 1910 d. 6 Aug 1993
11
Jesse N Smith Shumway
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.30.7]
b. 18 Mar 1912 d. 14 Dec 2000
Leoma Blanche Peterson
b. 3 Sep 1910 d. 3 Mar 1998
12
Marlene Shumway
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.30.7.1]
b. 26 Jul 1936 d. 16 Oct 1984
11
Janet Smith Shumway
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.30.8]
b. 30 Jul 1914 d. 22 Dec 1982
11
Lucy Shumway
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.30.9]
b. 10 Oct 1917 d. 28 Nov 1998
11
Margaret Shumway
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.30.10]
b. 10 Feb 1920 d. 2 Feb 2013
11
Julia Rosalind Shumway
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.30.11]
b. 20 Apr 1922 d. 22 Aug 2011
11
Nephi Grant Shumway
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.30.12]
b. 8 Mar 1925 d. 15 Oct 1944
10
Margaret Fife Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.31]
b. 6 Sep 1882 d. 28 Mar 1969
10
Ruth Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.32]
b. 17 Mar 1884 d. 31 Dec 1956
10
Esther Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.33]
b. 26 Oct 1887 d. 8 Dec 1975
10
Elias Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.34]
b. 1 Aug 1889 d. 23 Dec 1961
10
Leah Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.35]
b. 13 Aug 1891 d. 17 Feb 1976
Emma Ellen Larson
b. 6 Apr 1863 d. 2 Jun 1943
10
Hyrum Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.36]
b. 15 Dec 1882 d. 22 Mar 1971
10
Caroline Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.37]
b. 19 Nov 1884 d. 19 Jan 1924
10
Don Carlos Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.38]
b. 26 Sep 1886 d. 28 Oct 1967
10
Lorana Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.39]
b. 29 Nov 1888 d. 25 Apr 1979
10
Lehi Larson Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.40]
b. 19 Mar 1891 d. 28 Oct 1918
10
George Albert Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.41]
b. 7 May 1893 d. 31 Jan 1965
10
Aikens Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.42]
b. 29 Jul 1899 d. 17 Jul 1960
10
Myrtle Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.43]
b. 25 Oct 1901 d. 10 Jan 1977
10
Matthias Foss Cowley Smith
[1.1.1.1.5.3.5.7.10.44]
b. 1 Oct 1905 d. 5 Feb 1990
8
Patriarch John Smith
[1.1.1.1.5.3.5.8]
b. 16 Jul 1781 d. 23 May 1854
Clarissa Loomis Lyman
b. 27 Jun 1790 d. 14 Feb 1854
9
Daughter Smith
[1.1.1.1.5.3.5.8.1]
b. 9 May 1816 d. 9 May 1816
9
George Albert Smith
[1.1.1.1.5.3.5.8.2]
b. 26 Jun 1817 d. 1 Sep 1875
Bathsheba Wilson Bigler
b. 3 May 1822 d. 20 Sep 1910
10
George Albert Smith
[1.1.1.1.5.3.5.8.2.1]
b. 7 Jul 1842 bur. 8 Jan 1876
10
Son Smith
[1.1.1.1.5.3.5.8.2.2]
b. Abt 1844
10
Bathsheba Kate Smith
[1.1.1.1.5.3.5.8.2.3]
b. 14 Aug 1844 d. 22 Dec 1920
10
Daughter Smith
[1.1.1.1.5.3.5.8.2.4]
b. Abt 1846
10
John Henry Smith
[1.1.1.1.5.3.5.8.2.5]
b. 4 Apr 1847 d. 4 Apr 1847
Nancy A Clement
b. 31 Oct 1815 d. 26 Mar 1847
10
Lydia Crane
[1.1.1.1.5.3.5.8.2.6]
b. 1800 d. Oct 1827
10
Nancy Alida Crane
[1.1.1.1.5.3.5.8.2.7]
b. 20 Mar 1807 d. Dec 1882
10
Nancy Adelia Smith
[1.1.1.1.5.3.5.8.2.8]
b. 20 Mar 1846 d. 17 Apr 1847
10
Ellen Smith
[1.1.1.1.5.3.5.8.2.9]
b. Dec 1846 d. Apr 1847
Lucy Messerve Smith
b. 9 Feb 1817 d. 5 Oct 1892
10
Don Carlos Smith
[1.1.1.1.5.3.5.8.2.10]
b. 11 Aug 1846 d. 21 Jul 1847
10
Joel Smith
[1.1.1.1.5.3.5.8.2.11]
b. 6 Aug 1850 d. 6 Aug 1850
Zilpha Stark
b. 3 Jul 1818 d. 19 Sep 1887
10
Zilpha Adelade Smith
[1.1.1.1.5.3.5.8.2.12]
b. 12 Mar 1846 d. 12 May 1846
10
Joseph Smith
[1.1.1.1.5.3.5.8.2.13]
b. 2 Jan 1850 d. 8 Oct 1850
10
Mary Amelia Smith
[1.1.1.1.5.3.5.8.2.14]
b. 14 Feb 1852 d. 20 Mar 1915
Sarah Ann Libby
b. 7 May 1818 d. 12 Jun 1851
10
John Henry Smith
[1.1.1.1.5.3.5.8.2.15]
b. 18 Sep 1848 d. 13 Oct 1911
Sarah Farr
b. 30 Oct 1849 d. 4 Feb 1921
11
John Henry Smith
[1.1.1.1.5.3.5.8.2.15.1]
b. 22 Feb 1868 d. 20 Sep 1868
11
George Albert Smith
[1.1.1.1.5.3.5.8.2.15.2]
b. 4 Apr 1870 d. 4 Apr 1951
Lucy Emily Woodruff
b. 10 Jan 1869 d. 5 Nov 1937
12
Emily Smith
[1.1.1.1.5.3.5.8.2.15.2.1]
b. 20 Nov 1895 d. 28 Feb 1973
12
Edith Elliott
[1.1.1.1.5.3.5.8.2.15.2.2]
b. 10 Nov 1899 d. 13 Jun 1977
12
George Albert Smith, Jr
[1.1.1.1.5.3.5.8.2.15.2.3]
b. 10 Sep 1905 d. 11 Oct 1969
11
Lorin Farr Smith
[1.1.1.1.5.3.5.8.2.15.3]
b. 22 Apr 1872 d. 9 Jul 1872
11
Don Carlos Smith
[1.1.1.1.5.3.5.8.2.15.4]
b. 18 Mar 1874 d. 5 Jan 1927
11
Ezra Chase Smith
[1.1.1.1.5.3.5.8.2.15.5]
b. 21 Sep 1876 d. 28 Apr 1951
11
Charles Warren Smith
[1.1.1.1.5.3.5.8.2.15.6]
b. 3 Aug 1879 d. 7 Dec 1879
11
Winslow Farr Smith
[1.1.1.1.5.3.5.8.2.15.7]
b. 19 Jan 1881 d. 25 Dec 1966
11
Nathaniel Libby Smith
[1.1.1.1.5.3.5.8.2.15.8]
b. 19 Jun 1883 d. 1 Jul 1935
11
Joseph Harmon Smith
[1.1.1.1.5.3.5.8.2.15.9]
b. 17 Dec 1884 d. 23 May 1942
11
Tirzah Priscilla Smith
[1.1.1.1.5.3.5.8.2.15.10]
b. 11 Jun 1887 d. 12 Jun 1951
11
Elsie Louise Smith
[1.1.1.1.5.3.5.8.2.15.11]
b. 19 Oct 1891 d. 26 Dec 1956
Josephine Groesbeck
b. 13 Oct 1857 d. 1 Nov 1948
11
Sarah Ann Smith
[1.1.1.1.5.3.5.8.2.15.12]
b. 2 Oct 1878 d. 11 Feb 1938
11
Nicholas Groesbeck Smith
[1.1.1.1.5.3.5.8.2.15.13]
b. 20 Jun 1881 d. 27 Oct 1945
11
Joseph Harmon Smith
[1.1.1.1.5.3.5.8.2.15.14]
b. 17 Dec 1884 d. 23 May 1942
11
Lucy Smith
[1.1.1.1.5.3.5.8.2.15.15]
b. 24 Dec 1887 d. 7 Sep 1900
11
Elizabeth Smith
[1.1.1.1.5.3.5.8.2.15.16]
b. 30 Jan 1890 d. 9 Mar 1973
11
Glen Grosbeck Smith
[1.1.1.1.5.3.5.8.2.15.17]
b. 19 Sep 1893 d. 19 Jun 1970
11
Arzella Smith
[1.1.1.1.5.3.5.8.2.15.18]
b. 5 Nov 1895 d. 4 Jan 1969
11
Josephine Smith
[1.1.1.1.5.3.5.8.2.15.19]
b. 3 Jan 1898 d. 12 Aug 1973
Hannah Maria Libby
b. 29 Jun 1828 d. 21 Sep 1906
10
Charles Warren Smith
[1.1.1.1.5.3.5.8.2.16]
b. 16 Jan 1849 d. 25 Jan 1903
10
Sarah Maria Smith
[1.1.1.1.5.3.5.8.2.17]
b. 1 Jan 1856 d. 16 Jan 1912
10
Eunice Albertine Smith
[1.1.1.1.5.3.5.8.2.18]
b. 6 Mar 1860 d. 4 Oct 1861
10
George Albert Smith
[1.1.1.1.5.3.5.8.2.19]
b. 7 Apr 1862 d. 28 Oct 1863
10
Grace Libby Smith
[1.1.1.1.5.3.5.8.2.20]
b. 14 May 1865 d. 27 Feb 1939
Susan Elizabeth West
b. 4 Dec 1833 d. 6 Jul 1935
10
Clarissa West Smith
[1.1.1.1.5.3.5.8.2.21]
b. 21 Apr 1859 d. 8 Mar 1930
10
Margaret West Smith
[1.1.1.1.5.3.5.8.2.22]
b. 6 Dec 1862 d. 18 Jun 1913
10
Elizabeth Smith
[1.1.1.1.5.3.5.8.2.23]
b. 28 Sep 1866 d. 6 Jan 1921
10
Priscilla Smith
[1.1.1.1.5.3.5.8.2.24]
b. 11 Jun 1869 d. 3 Nov 1907
10
Emma Pearl Smith
[1.1.1.1.5.3.5.8.2.25]
b. 19 Apr 1871 d. 6 Oct 1905
9
Caroline Clara Smith
[1.1.1.1.5.3.5.8.3]
b. 6 Jun 1820 d. 8 Jan 1895
Thomas Callister
b. 8 Jul 1821 d. 1 Dec 1880
10
Thomas Callister
[1.1.1.1.5.3.5.8.3.1]
b. 13 Sep 1846 d. 8 May 1847
10
Clarissa Callister
[1.1.1.1.5.3.5.8.3.2]
b. 28 May 1848 d. 4 Oct 1848
10
Clara Caroline Callister
[1.1.1.1.5.3.5.8.3.3]
b. 18 Apr 1850 d. 22 Sep 1892
10
Philomela Callister
[1.1.1.1.5.3.5.8.3.4]
b. 11 Jul 1851 d. 22 Feb 1879
10
Mary Maranda Callister
[1.1.1.1.5.3.5.8.3.5]
b. 17 Aug 1853 d. 14 May 1930
10
Samuel Jay Callister
[1.1.1.1.5.3.5.8.3.6]
b. 14 Jan 1856 d. 14 Jan 1856
10
Bathsheba Smith Callister
[1.1.1.1.5.3.5.8.3.7]
b. 21 Sep 1860 d. 1 Nov 1860
9
John Lyman Smith
[1.1.1.1.5.3.5.8.4]
b. 17 Nov 1828 d. 21 Feb 1898
8
Susannah Smith
[1.1.1.1.5.3.5.9]
b. 18 May 1783 d. 22 Mar 1849
+
John Hall
8
Stephen Smith
[1.1.1.1.5.3.5.10]
b. 23 Apr 1785 d. 25 Jul 1802
+
Sally Hadley
8
Sarah Smith
[1.1.1.1.5.3.5.11]
b. 16 May 1789 d. 27 May 1824
Joseph Sanford
b. 1785 d. 11 Sep 1825
9
Martin Sanford
[1.1.1.1.5.3.5.11.1]
b. 24 Sep 1811 d. 24 Nov 1817
9
Martin Sanford
[1.1.1.1.5.3.5.11.2]
b. 4 Nov 1812 d. 3 Dec 1820
9
Joseph Sanford
[1.1.1.1.5.3.5.11.3]
b. 1813 d. 1816
9
Charlette Sanford
[1.1.1.1.5.3.5.11.4]
b. 4 Mar 1814 d. Abt 1858
9
William Wallace Sanford
[1.1.1.1.5.3.5.11.5]
b. 13 Jun 1816 d. 1844
9
John Lyman Sanford
[1.1.1.1.5.3.5.11.6]
b. 20 May 1818
6
Rebecca Smith
[1.1.1.1.5.4]
b. 1 Oct 1715 d. 1 Mar 1794
John Balch
b. 25 Apr 1715 d. 31 Dec 1774
7
David Balch
[1.1.1.1.5.4.1]
b. 4 Jan 1740 d. 31 Jul 1801
7
Samuel Balch
[1.1.1.1.5.4.2]
b. 20 Mar 1742 d. 1820
7
John Balch
[1.1.1.1.5.4.3]
b. 26 Mar 1742 d. 25 Jul 1798
7
Robert Balch
[1.1.1.1.5.4.4]
b. 28 Jul 1743
7
Hannah Balch
[1.1.1.1.5.4.5]
b. 15 Mar 1746
7
Cornelius Balch
[1.1.1.1.5.4.6]
b. 26 Nov 1749 d. 21 May 1795
7
William Balch
[1.1.1.1.5.4.7]
b. 1752 d. 22 Mar 1764
7
Roger Balch
[1.1.1.1.5.4.8]
b. 26 May 1753 d. 8 Jan 1842
7
Rebecca Balch
[1.1.1.1.5.4.9]
b. 27 Mar 1758
6
Elizabeth Smith
[1.1.1.1.5.5]
b. 8 Jul 1718 d. 27 Mar 1753
Eleazar Gould
b. 29 May 1720 d. Jun 1795
7
Zaccheus Gould
[1.1.1.1.5.5.1]
b. 5 Feb 1743 d. 13 Feb 1823
7
John Gould
[1.1.1.1.5.5.2]
b. 5 Mar 1745
7
Hulda Gould
[1.1.1.1.5.5.3]
b. 1 Aug 1748 d. 11 Oct 1748
6
Hephzibah Smith
[1.1.1.1.5.6]
b. 12 May 1722 d. 15 Nov 1774
+
William Gallup
b. 4 Oct 1722 d. 29 Sep 1805
6
Robert Smith
[1.1.1.1.5.7]
b. 28 Feb 1724 d. 17 Mar 1795
Susannah Gould
b. 19 Feb 1723 d. Abt 1773
7
Elijah Smith
[1.1.1.1.5.7.1]
b. 5 Dec 1746 d. 5 Nov 1839
7
Elisha Smith
[1.1.1.1.5.7.2]
b. 4 Oct 1748
7
Joseph Smith
[1.1.1.1.5.7.3]
b. 9 Jun 1751
7
Elizabeth Smith
[1.1.1.1.5.7.4]
b. 20 Apr 1753 d. 10 Apr 1797
7
Rebeckah Smith
[1.1.1.1.5.7.5]
b. 8 May 1758 d. 8 Sep 1839
7
Thomas Smith
[1.1.1.1.5.7.6]
b. 10 Mar 1760 d. 3 Oct 1846
7
Silas Smith
[1.1.1.1.5.7.7]
b. 30 May 1772
7
Jedediah Smith
[1.1.1.1.5.7.8]
b. 30 May 1772
+
Abigail Waters
b. 5 Jun 1744
6
Susanna Smith
[1.1.1.1.5.8]
b. 2 May 1726 d. 29 Nov 1741
6
Hannah Smith
[1.1.1.1.5.9]
b. 15 Apr 1729 d. 17 Aug 1764
John Peabody
b. 10 Sep 1730 d. 29 Jan 1802
7
Hannah Peabody
[1.1.1.1.5.9.1]
b. 6 Oct 1757 d. 9 Oct 1802
7
Mehitable Peabody
[1.1.1.1.5.9.2]
b. 11 Mar 1759 d. 5 May 1759
7
Deborah Peabody
[1.1.1.1.5.9.3]
b. 27 Mar 1760 d. 27 Jan 1842
7
John Peaboddy
[1.1.1.1.5.9.4]
b. 11 Jul 1762 d. 22 Jan 1836
7
Mehitable Peabody
[1.1.1.1.5.9.5]
b. Aug 1764 d. 1 Dec 1849
6
John Smith
[1.1.1.1.5.10]
b. 13 Apr 1738 d. 1 Jul 1760
Martha Towne
b. 1739 d. Aft 1762
7
John Smith
[1.1.1.1.5.10.1]
b. Abt 1760
7
Amos Smith
[1.1.1.1.5.10.2]
b. 4 Feb 1762
5
Amye Smith
[1.1.1.1.6]
b. 16 Aug 1668 d. 22 Feb 1756
Joseph Towne
b. 2 Feb 1661 d. 18 May 1717
6
Captain Benjamin Towne
[1.1.1.1.6.1]
b. 10 May 1691 d. 11 Feb 1772
6
Daniel Towne
[1.1.1.1.6.2]
b. 22 Aug 1695
6
Jesse Towne
[1.1.1.1.6.3]
b. 5 Dec 1697 d. 28 Apr 1754
6
Nathan Towne
[1.1.1.1.6.4]
b. 1 Jun 1700 d. 5 Jan 1762
Jemima Perkins
b. Abt 1702
7
Jemima Towne
[1.1.1.1.6.4.1]
b. 20 May 1724 d. 15 Nov 1774
7
Nathaniel Towne, Jr
[1.1.1.1.6.4.2]
b. 16 Sep 1725 d. 1745
7
Eunes Towne
[1.1.1.1.6.4.3]
b. 4 Feb 1727
7
Sarah Towne
[1.1.1.1.6.4.4]
b. 1 Sep 1729
7
Prudence Towne
[1.1.1.1.6.4.5]
b. 16 Nov 1732
7
Anna Towne
[1.1.1.1.6.4.6]
b. 9 Mar 1734
7
Deacon Francis Towne
[1.1.1.1.6.4.7]
b. 27 Jul 1737 d. 11 Aug 1811
6
Amy Towne
[1.1.1.1.6.5]
b. 3 Feb 1704 d. 1747
6
Amos Towne
[1.1.1.1.6.6]
b. 2 Jul 1709 d. 14 Feb 1747
Mary Smith
b. 14 Aug 1711 d. 14 Nov 1785
7
Samuel Towne
[1.1.1.1.6.6.1]
b. Abt 1735
7
Amos Towne
[1.1.1.1.6.6.2]
b. Oct 1737 d. 8 Sep 1793
7
Daniel Towne
[1.1.1.1.6.6.3]
b. 28 Oct 1739
5
Sarah Smith
[1.1.1.1.7]
b. 26 Jun 1670 d. 28 Aug 1673
5
Nathaniel Smith
[1.1.1.1.8]
b. 7 Sep 1672 d. 1719
Mary Dickenson
b. 2 Feb 1672 d. 16 Aug 1718
6
Nathanial Smith
[1.1.1.1.8.1]
b. 1 Jan 1698 d. 13 Dec 1789
6
Joshua Smith
[1.1.1.1.8.2]
b. 11 Sep 1705 d. 28 Sep 1741
6
Hannah Smith
[1.1.1.1.8.3]
b. 7 Mar 1706
6
Martha Smith
[1.1.1.1.8.4]
b. 31 Jan 1708 d. 3 Oct 1794
6
Lydia Smith
[1.1.1.1.8.5]
b. 16 Mar 1711 d. 1 Oct 1804
Samuel Morton
b. 8 Sep 1709 d. 3 Jan 1793
7
Lydia Morton
[1.1.1.1.8.5.1]
b. 11 Aug 1731 d. 1778
7
Abigail Morton
[1.1.1.1.8.5.2]
b. 1 Sep 1733 d. 16 Sep 1823
7
Abner Morton
[1.1.1.1.8.5.3]
b. 17 Jan 1736 d. 5 Feb 1823
7
Jerusha Morton
[1.1.1.1.8.5.4]
b. 6 Mar 1737 d. 4 May 1834
Jonas Bradish
b. 7 Aug 1724
8
Daniel Bradish
[1.1.1.1.8.5.4.1]
b. 30 Apr 1761 d. 4 Nov 1855
8
Jonas Bradish
[1.1.1.1.8.5.4.2]
b. 13 Apr 1763
8
Aaron Bradish
[1.1.1.1.8.5.4.3]
b. 16 Jan 1766 d. 17 Feb 1832
8
Josiah Bradish
[1.1.1.1.8.5.4.4]
b. 20 Feb 1768 d. 1835
8
Joshua Bradish
[1.1.1.1.8.5.4.5]
b. 13 Apr 1770 d. 24 Apr 1845
8
James Bradish
[1.1.1.1.8.5.4.6]
b. 1772
8
Samuel Morton Bradish
[1.1.1.1.8.5.4.7]
b. Abt 1774 d. 1812
7
Lois Morton
[1.1.1.1.8.5.5]
b. 6 Apr 1740
7
Joshua Morton
[1.1.1.1.8.5.6]
b. 20 Oct 1744 d. 13 Feb 1827
7
Samuel Whitney Morton
[1.1.1.1.8.5.7]
b. 5 Nov 1746
7
Samuel Jillit Morton
[1.1.1.1.8.5.8]
b. 1748 d. 3 Jan 1793
7
Martha Morton
[1.1.1.1.8.5.9]
b. 8 Sep 1749 d. 11 Aug 1829
7
Thomas Morton
[1.1.1.1.8.5.10]
b. 15 Aug 1752 d. 20 Nov 1756
6
Mary Coleman
[1.1.1.1.8.6]
b. 14 Jul 1712 d. 28 Nov 1780
6
Jerusah Smith
[1.1.1.1.8.7]
b. 9 Jan 1713 d. 1809
5
Jacob Smith
[1.1.1.1.9]
b. 26 Jan 1674 d. 8 Dec 1748
Rebecca Symonds
b. 1686
6
Rebackah Smith
[1.1.1.1.9.1]
b. 1707 d. Abt 1794
6
Joseph Smith
[1.1.1.1.9.2]
b. 23 May 1713
6
Keziah Smith
[1.1.1.1.9.3]
b. 30 Apr 1716 d. 23 Aug 1762
6
Moses Smith
[1.1.1.1.9.4]
b. 1718
6
Ruth Smith
[1.1.1.1.9.5]
b. 21 Sep 1721 d. 1744
6
Nathaniel Smith
[1.1.1.1.9.6]
b. 5 Aug 1724 d. Jan 1802
5
Mariah Smith
[1.1.1.1.10]
b. 18 Dec 1677 d. 17 Jan 1739
+
Peter Shumway
b. 6 Jun 1678 d. 17 May 1741
4
Thomas French
[1.1.1.2]
b. 1635 d. 14 Dec 1661
Mary Adams
b. 1639 d. 1721
5
Mary French
[1.1.1.2.1]
b. 9 Mar 1662 d. 13 May 1753
+
John Stiles
b. 20 Jun 1661 d. 16 May 1700
5
Thomas French
[1.1.1.2.2]
b. 21 May 1666 d. 2 Jan 1752
5
Abigail French
[1.1.1.2.3]
b. 27 Jun 1668 d. 17 Oct 1703
5
Hannah French
[1.1.1.2.4]
b. 30 Jan 1670 d. 11 Mar 1717
Jethro Wheeler
b. 1664 d. 1725
6
Jethro Wheeler
[1.1.1.2.4.1]
b. 19 Aug 1692
6
Benjamin Wheeler
[1.1.1.2.4.2]
b. 23 May 1694 d. 1 Jan 1779
6
Moses Wheeler
[1.1.1.2.4.3]
b. Abt 1700 d. 23 Feb 1789
6
Abigail Wheeler
[1.1.1.2.4.4]
b. 1702
6
John Wheeler
[1.1.1.2.4.5]
b. 1710
5
William French
[1.1.1.2.5]
b. 30 Nov 1673 d. 15 Nov 1764
Abigail Wiggin
b. 14 Sep 1678 d. 1748
6
Bradstreet French
[1.1.1.2.5.1]
b. 1699
6
Thomas French
[1.1.1.2.5.2]
b. 1701
6
Abigail French
[1.1.1.2.5.3]
b. Abt 1703
6
David French
[1.1.1.2.5.4]
b. 1705
6
William French
[1.1.1.2.5.5]
b. 1707 d. Jan 1790
6
Mary French
[1.1.1.2.5.6]
b. 1712 d. 1803
6
Hannah French
[1.1.1.2.5.7]
b. 1714
6
Sarah French
[1.1.1.2.5.8]
b. 1718
6
Simon French
[1.1.1.2.5.9]
b. 1722
5
Hester French
[1.1.1.2.6]
b. 2 Jan 1676
4
John French
[1.1.1.3]
b. Feb 1635 d. 15 Mar 1706
Phebe Keyes
b. 17 Jun 1639 d. 14 May 1701
5
Mary French
[1.1.1.3.1]
b. 1661 d. 27 Sep 1730
Stephen Pearson
b. 11 Nov 1664 d. 28 Jan 1706
6
Elisabeth Pearson
[1.1.1.3.1.1]
b. 5 Aug 1685 d. 10 May 1746
6
Stephen Pearson
[1.1.1.3.1.2]
b. Abt 1686 d. 18 Mar 1772
6
Martha Pearson
[1.1.1.3.1.3]
b. 6 Jul 1689 d. 26 Oct 1752
6
Mary Pearson
[1.1.1.3.1.4]
b. 7 Jun 1690
6
Jonathan Pearson
[1.1.1.3.1.5]
b. 9 Oct 1693 d. 11 Dec 1693
6
Patience Pearson
[1.1.1.3.1.6]
b. 1697 d. 29 Dec 1773
6
Hephsibah Pearson
[1.1.1.3.1.7]
b. 20 Jan 1699 d. 30 Oct 1771
5
Richard French
[1.1.1.3.2]
b. 18 Aug 1676 d. 13 May 1757
Elizabeth
b. Abt 1676
6
Amy French
[1.1.1.3.2.1]
b. 6 May 1700 d. 8 Mar 1757
6
Elizabeth French
[1.1.1.3.2.2]
b. 3 Aug 1702 d. 1746
6
Phebe French
[1.1.1.3.2.3]
b. 1704 d. 1 Apr 1705
6
Ephraim French
[1.1.1.3.2.4]
b. 15 May 1708 d. 1780
6
Experience French
[1.1.1.3.2.5]
b. 3 Aug 1710 d. 4 Mar 1791
6
Richard French
[1.1.1.3.2.6]
b. 1712 d. 1759
6
Hepzibath French
[1.1.1.3.2.7]
b. 9 Dec 1714 d. 1745
6
John French
[1.1.1.3.2.8]
b. 1716 d. 1775
6
Alice French
[1.1.1.3.2.9]
b. 30 Apr 1720 d. 2 Dec 1778
4
Samuel French
[1.1.1.4]
b. 1639 d. 1688
+
Elizabeth Kemp
b. 1645
4
Ephraim French
[1.1.1.5]
b. 2 Mar 1643 d. Sep 1716
4
Sarah French
[1.1.1.6]
b. Abt 1645 d. 19 May 1717
Nathaniel Hayden
b. 6 Jun 1648 d. 20 Apr 1706
5
Experience Hayden
[1.1.1.6.1]
b. 15 May 1679 d. Aft 1719
5
Hannah Hayden
[1.1.1.6.2]
b. 9 Feb 1680 d. 20 Oct 1736
Joseph Kelsey
b. 25 Dec 1673 d. 8 Mar 1740
6
Jemima Kelsey
[1.1.1.6.2.1]
b. 22 Mar 1701 d. 28 Sep 1775
6
Margaret Kelsey
[1.1.1.6.2.2]
b. 8 Oct 1702 d. 17 Sep 1752
6
Keziah Kelsey
[1.1.1.6.2.3]
b. 5 Mar 1704 d. 1763
Josiah Wilcox
b. 4 Apr 1706
7
Eliab Wilcox
[1.1.1.6.2.3.1]
b. 23 Feb 1731 d. 20 Jan 1810
7
Anna Wilcox
[1.1.1.6.2.3.2]
b. 23 Apr 1735 d. 30 Oct 1835
7
Roswell Wilcox
[1.1.1.6.2.3.3]
b. 31 Dec 1736 d. 23 May 1819
7
Josiah Wilcox
[1.1.1.6.2.3.4]
b. 4 May 1739 d. 18 Jan 1832
7
Keziah Wilcox
[1.1.1.6.2.3.5]
b. 3 Jun 1742
7
Elizabeth Wilcox
[1.1.1.6.2.3.6]
b. 11 Mar 1744
7
Abner Wilcox
[1.1.1.6.2.3.7]
b. 10 Jul 1748 d. 20 Jan 1837
7
John Wilcox
[1.1.1.6.2.3.8]
b. 4 Oct 1756 d. 1860
Marjorie Deborah Day
b. Abt 1759 d. 1825
8
Amy Wilcox
[1.1.1.6.2.3.8.1]
b. 1780
8
Hannah Wilcox
[1.1.1.6.2.3.8.2]
b. 1782 d. 1864
William Porter
b. 18 Mar 1782 d. 1855
9
David Porter
[1.1.1.6.2.3.8.2.1]
b. Mar 1799 d. 8 Dec 1879
9
Ruth Hannah Porter
[1.1.1.6.2.3.8.2.2]
b. 11 Jun 1800 d. Aft 10 Mar 1862
9
John Porter
[1.1.1.6.2.3.8.2.3]
b. 1804
9
Latney Day Porter
[1.1.1.6.2.3.8.2.4]
b. 1808 d. 30 Sep 1880
Sophrona Brown
b. 28 Feb 1828 d. 5 Mar 1907
10
John P. Porter
[1.1.1.6.2.3.8.2.4.1]
b. 14 Jun 1844 d. 1917
10
Samuel Porter
[1.1.1.6.2.3.8.2.4.2]
b. 10 Dec 1846 d. 15 Sep 1858
10
Aaron Porter
[1.1.1.6.2.3.8.2.4.3]
b. 1849 d. 19 Sep 1872
10
Case Henry Porter
[1.1.1.6.2.3.8.2.4.4]
b. 3 Jul 1850 d. 18 May 1876
10
Palmer Porter
[1.1.1.6.2.3.8.2.4.5]
b. 12 Dec 1852 d. 14 Apr 1853
10
Clara Porter
[1.1.1.6.2.3.8.2.4.6]
b. 9 May 1855 d. 29 Sep 1887
10
Latney James Porter
[1.1.1.6.2.3.8.2.4.7]
b. 22 Jun 1857 d. 12 Mar 1926
Elizabeth Gleockler
b. 8 May 1860 d. 3 May 1900
11
Roseltha Porter
[1.1.1.6.2.3.8.2.4.7.1]
b. 5 Aug 1881 d. 23 Nov 1963
Joseph Grant Wareing
b. 9 Jul 1872 d. 28 Feb 1942
12
George Grant Wareing
[1.1.1.6.2.3.8.2.4.7.1.1]
b. 21 Aug 1902 d. 8 Sep 1970 [
=>
]
12
Marvin LaVere "Pete" Wareing
[1.1.1.6.2.3.8.2.4.7.1.2]
b. 26 Jul 1908 d. 15 Mar 1991 [
=>
]
11
George Porter
[1.1.1.6.2.3.8.2.4.7.2]
b. 16 Jan 1883 d. 21 Feb 1971
11
Bertha Arvilla Porter
[1.1.1.6.2.3.8.2.4.7.3]
b. 10 Aug 1885 d. 29 Mar 1962
11
Floyd Porter
[1.1.1.6.2.3.8.2.4.7.4]
b. 4 Jul 1891 d. 13 Mar 1963
11
Clarence Dewey Porter
[1.1.1.6.2.3.8.2.4.7.5]
b. 1 Mar 1898 d. 19 Mar 1972
11
Irvin Charles Porter
[1.1.1.6.2.3.8.2.4.7.6]
b. 15 Mar 1900 d. 21 May 1985
10
Loretta Hannah Porter
[1.1.1.6.2.3.8.2.4.8]
b. 5 Jan 1860 d. 1906
10
Harriet Porter
[1.1.1.6.2.3.8.2.4.9]
b. 5 May 1861 d. 15 Jul 1929
10
Ulysses S Grant Porter
[1.1.1.6.2.3.8.2.4.10]
b. 8 May 1864 d. 30 Aug 1917
10
P. Geary Porter
[1.1.1.6.2.3.8.2.4.11]
b. 2 Oct 1866 d. 30 Aug 1917
10
Sarah C Porter
[1.1.1.6.2.3.8.2.4.12]
b. 3 Apr 1870 d. Feb 1932
10
Clarence Lee Porter
[1.1.1.6.2.3.8.2.4.13]
b. 7 Jan 1872 d. 5 Feb 1962
9
Minor T Porter
[1.1.1.6.2.3.8.2.5]
b. 12 Mar 1810 d. 26 Dec 1893
9
Amy Porter
[1.1.1.6.2.3.8.2.6]
b. 1 Apr 1812 d. 26 Mar 1910
9
William Porter, Jr
[1.1.1.6.2.3.8.2.7]
b. 1814 d. 16 Jan 1864
9
Clarinda Porter
[1.1.1.6.2.3.8.2.8]
b. 1816 d. 1910
9
Daniel Porter
[1.1.1.6.2.3.8.2.9]
b. 14 Mar 1818 d. 7 Sep 1905
9
Israel Porter
[1.1.1.6.2.3.8.2.10]
b. 18 Feb 1820 d. 15 Mar 1898
9
Albert Porter
[1.1.1.6.2.3.8.2.11]
b. Jun 1822 d. 23 Dec 1855
9
Ensel Porter
[1.1.1.6.2.3.8.2.12]
b. 1827
8
Nathan Wilcox
[1.1.1.6.2.3.8.3]
b. 1785 d. 1877
8
Ruth Hannah Wilcox
[1.1.1.6.2.3.8.4]
b. Abt 1788
8
Samuel Wilcox
[1.1.1.6.2.3.8.5]
b. 1789 d. 22 Aug 1848
8
Gideon Wilcox
[1.1.1.6.2.3.8.6]
b. 16 Oct 1792
8
John Day Wilcox
[1.1.1.6.2.3.8.7]
b. 14 Oct 1794 d. 4 Mar 1865
8
Chloe Wilcox
[1.1.1.6.2.3.8.8]
b. 1795
8
Susan Wilcox
[1.1.1.6.2.3.8.9]
b. Abt 1797
8
Nancy Wilcox
[1.1.1.6.2.3.8.10]
b. 1799 d. 11 May 1860
8
Mary Wilcox
[1.1.1.6.2.3.8.11]
b. 22 Apr 1804 d. 30 Jun 1885
6
Joseph Kelsey
[1.1.1.6.2.4]
b. 10 Oct 1708 d. 7 Aug 1800
6
Damaris Kelsey
[1.1.1.6.2.5]
b. 13 Apr 1711 d. 3 Jun 1803
6
Silas Kelsey
[1.1.1.6.2.6]
b. 11 Feb 1713 d. 18 Mar 1713
6
Abagail Kelsey
[1.1.1.6.2.7]
b. 16 Aug 1717 d. 5 Sep 1743
6
Gideon Kelsey
[1.1.1.6.2.8]
b. 1 Apr 1718 d. 5 Mar 1764
6
Josiah Kelsey
[1.1.1.6.2.9]
b. 1 Aug 1721 d. 9 Feb 1758
6
Abner Kesley
[1.1.1.6.2.10]
b. 10 Aug 1724
5
Concurrence Hayden
[1.1.1.6.3]
b. Oct 1685 d. Oct 1753
5
Sarah Hayden
[1.1.1.6.4]
b. Abt 1690
3
Alice French
[1.1.2]
b. 9 Oct 1609 d. 26 Jun 1666
Thomas Howlett
b. 1605 d. 22 Dec 1677
4
Sarah Howlett
[1.1.2.1]
b. 3 Mar 1634 d. 7 Dec 1700
4
Mary Howlett
[1.1.2.2]
b. Abt 1662 d. 24 Oct 1727
3
Edward French
[1.1.3]
b. Abt 1610 d. 28 Dec 1674
+
Ann Goodale
b. 1611 d. 9 Mar 1683
3
John French
[1.1.4]
b. 26 May 1612 d. 6 Aug 1692
Grace Kingsley
b. 1621 d. 28 Feb 1681
4
Elisabeth French
[1.1.4.1]
b. 1640 bur. 3 Oct 1703
Jonathan Thayer
b. 18 Jan 1658 d. 1690
5
Huldah Thayer
[1.1.4.1.1]
b. 11 Mar 1682 d. 7 Jul 1739
Benjamin Wheelock
b. 12 Dec 1678 d. 13 Sep 1746
6
Benjamin Wheelock
[1.1.4.1.1.1]
b. 10 Apr 1704 d. 1777
Deborah Taft
b. 14 Nov 1702 d. 9 Aug 1747
7
Benjamin Wheelock
[1.1.4.1.1.1.1]
b. 17 Aug 1729 d. 16 Apr 1776
7
Jesse Wheelock
[1.1.4.1.1.1.2]
b. 8 Sep 1731 d. Bef 4 Sep 1781
Phoebe White
b. 8 Oct 1737 d. Mar 1783
8
Phineas Wheelock
[1.1.4.1.1.1.2.1]
b. 28 Apr 1754 d. 21 Jun 1759
8
Enock Wheelock
[1.1.4.1.1.1.2.2]
b. 14 Oct 1755
8
Mary Wheelock
[1.1.4.1.1.1.2.3]
b. 23 May 1756 d. 5 Nov 1807
8
Nathan Wheelock
[1.1.4.1.1.1.2.4]
b. 20 Apr 1758
8
Nancy Wheelock
[1.1.4.1.1.1.2.5]
b. 14 Nov 1767 d. 9 Oct 1843
8
Abigail Wheelock
[1.1.4.1.1.1.2.6]
b. 16 Jan 1772
8
Baruch Wheelock
[1.1.4.1.1.1.2.7]
b. 4 Jan 1774 d. 28 Mar 1816
8
Submit Wheelock
[1.1.4.1.1.1.2.8]
b. 10 Jan 1782 d. 29 Jan 1823
7
Jonathan Wheelock
[1.1.4.1.1.1.3]
b. 8 Sep 1731 d. 1774
Ruth Daniels
b. 13 Jul 1738 d. 26 Sep 1798
8
Eleazer Wheelock
[1.1.4.1.1.1.3.1]
b. 15 Jul 1756 d. 1841
8
Dole Wheelock
[1.1.4.1.1.1.3.2]
b. 29 May 1758
8
Susannah Wheelock
[1.1.4.1.1.1.3.3]
b. 23 Feb 1760 d. 2 May 1776
8
Lyman Wheelock
[1.1.4.1.1.1.3.4]
b. 30 Nov 1761 d. 29 Mar 1848
8
Alphaeus Wheelock
[1.1.4.1.1.1.3.5]
b. 17 Dec 1763
8
Willard Wheelock
[1.1.4.1.1.1.3.6]
b. 19 Jun 1768 d. 29 Mar 1823
8
Deobrah Wheelock
[1.1.4.1.1.1.3.7]
b. 17 Dec 1765 d. 3 Aug 1846
Elkanah Benson
b. 21 Feb 1766 d. 8 Mar 1844
9
Samuel Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.1]
b. 21 May 1791
Mary Van Liew
b. 8 Jul 1797 d. 22 Apr 1859
10
William Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.1.1]
b. 18 Dec 1817
10
Emily Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.1.2]
b. 18 Dec 1817
+
George Van Heusen
b. 3 Jun 1816 d. 25 Mar 1872
10
Alzina Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.1.3]
b. 8 Nov 1819 d. 29 Mar 1867
+
Charles W Ingersoll
b. 1817
10
Augustus Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.1.4]
b. 10 Feb 1822
10
Phila Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.1.5]
b. 8 Mar 1824
William Jenkins
b. 1820 d. 14 May 1864
11
Walter Jenkins
[1.1.4.1.1.1.3.7.1.5.1]
b. 1857 d. 14 May 1864
11
Emma Jenkins
[1.1.4.1.1.1.3.7.1.5.2]
b. 1861
10
Nathan S Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.1.6]
b. 17 Sep 1826 d. 1869
Martha Mead
b. 1838
11
Cora Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.1.6.1]
b. Abt 1860
11
Florence E Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.1.6.2]
b. Feb 1862
11
Alice Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.1.6.3]
b. Abt 1864
11
Nellie Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.1.6.4]
b. Abt 1866
10
James Mapes Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.1.7]
b. 12 Jun 1828 d. 11 Oct 1907
Margaret Jane Williamson
b. 4 Dec 1834 d. 20 Feb 1905
11
Francis Coe Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.1.7.1]
b. 22 Feb 1860
11
James Clarence Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.1.7.2]
b. 24 May 1862 d. 12 Jul 1920
Frances Leona Wilkerson
b. 20 Dec 1878 d. 5 Sep 1962
12
James Claude Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.1.7.2.1]
b. 21 Nov 1896 d. 11 Dec 1977
12
Karyl Vivian Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.1.7.2.2]
b. 26 Jan 1899 d. 30 Aug 1957
12
Frank Percy Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.1.7.2.3]
b. 26 Feb 1900 d. 18 Sep 1900
12
John Clifford Earl Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.1.7.2.4]
b. 26 Jun 1901 d. 20 Nov 1964
12
Margaret Leona Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.1.7.2.5]
b. 28 May 1905 d. 7 Dec 1967 [
=>
]
12
Martha Louise Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.1.7.2.6]
b. 1 Mar 1908 d. 26 Jun 1909
12
Louis Clair Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.1.7.2.7]
b. 6 Jun 1912 d. 24 Sep 1984
12
Beryl Christine Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.1.7.2.8]
b. 24 Nov 1913 d. 20 Nov 1964 [
=>
]
10
Montgomery Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.1.8]
b. Abt 1833
10
Mary Ellen Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.1.9]
b. Abt 1839
+
Cyrus B Kinne
b. Jan 1835
9
Chloe Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.2]
b. 6 Jan 1793 d. 1882
Lewis Smith
b. Abt 1790
10
Mary Smith
[1.1.4.1.1.1.3.7.2.1]
b. Abt 1813 d. 1913
+
Henry Gilman Darling
b. 16 Aug 1810 d. 17 Dec 1870
10
Sidney Smith
[1.1.4.1.1.1.3.7.2.2]
b. 29 Jan 1815 d. 10 Sep 1900
Jennie Ann Calkins
b. 1835
11
Adelia Smith
[1.1.4.1.1.1.3.7.2.2.1]
b. Apr 1866
Herman Frank Miner
b. 1854 d. Feb 1905
12
Sidney Louise Miner
[1.1.4.1.1.1.3.7.2.2.1.1]
b. May 1891
11
Anna Smith
[1.1.4.1.1.1.3.7.2.2.2]
b. 1869
10
William Smith
[1.1.4.1.1.1.3.7.2.3]
b. Abt 1817
10
Lewis Smith
[1.1.4.1.1.1.3.7.2.4]
b. Abt 1820
10
Stephen Smith
[1.1.4.1.1.1.3.7.2.5]
b. 19 Feb 1823 d. 26 Aug 1922
Lucy Colver
b. 13 Oct 1835 d. 12 Sep 1905
11
Florence Nightingale Smith
[1.1.4.1.1.1.3.7.2.5.1]
b. 8 Nov 1861
+
Walter Clark Mason
b. 1859
11
Evangeline Smith
[1.1.4.1.1.1.3.7.2.5.2]
b. Abt 1863 d. Abt 1868
11
Sidney Smith
[1.1.4.1.1.1.3.7.2.5.3]
b. 23 Dec 1864
11
Caroline Smith
[1.1.4.1.1.1.3.7.2.5.4]
b. 4 Aug 1866 d. 11 Mar 1868
11
Stephen Smith
[1.1.4.1.1.1.3.7.2.5.5]
b. 27 Dec 1868 d. 8 Jan 1889
11
Evalyn C Smith
[1.1.4.1.1.1.3.7.2.5.6]
b. 28 Dec 1868
11
Lucille Carroll Smith
[1.1.4.1.1.1.3.7.2.5.7]
b. 30 Jan 1873
+
James Madison Pratt
b. 1871
11
Dean Smith
[1.1.4.1.1.1.3.7.2.5.8]
b. 28 Aug 1875
11
Anna Jaffray Smith
[1.1.4.1.1.1.3.7.2.5.9]
b. 8 Jun 1878
+
Maurice Philip Gould
10
Job Lewis Smith
[1.1.4.1.1.1.3.7.2.6]
b. 15 Oct 1827 d. 9 Jun 1897
9
Adolphus Willard Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.3]
b. 17 Dec 1795 d. 18 May 1878
Hannah Vermilyea
b. 1796 d. 28 Jun 1886
10
Edward Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.3.1]
b. 1824
10
Bryon L Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.3.2]
b. 25 Dec 1825 d. 23 Oct 1912
Angelina Howard
b. 16 Jul 1836 d. 24 Nov 1922
11
Alice Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.3.2.1]
b. 15 Aug 1858 d. 19 May 1879
10
Lewis Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.3.3]
b. Abt 1827
10
Elizabeth Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.3.4]
b. Abt 1829
10
Ellen Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.3.5]
b. Abt 1831
10
John Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.3.6]
b. Abt 1833
10
Henry Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.3.7]
b. Abt 1835
10
Jane H Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.3.8]
b. Abt 1837
10
Frank Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.3.9]
b. Abt 1839
9
Eliza Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.4]
b. 9 Mar 1798 d. 13 Nov 1817
+
James Miller
b. Abt 1795
9
Leonard Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.5]
b. 7 Apr 1800 d. 7 Sep 1877
Ruth Ann Reynolds
b. 23 Jul 1805 d. 2 Feb 1853
10
Elisha Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.5.1]
b. 1829
Helen R Sherman
b. 1839
11
Hattie Isabel Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.5.1.1]
b. Abt 1860
+
Charles Augustus Stratton
b. 16 Aug 1856 d. 24 Jan 1937
11
Carrie A Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.5.1.2]
b. 4 Dec 1861 d. 1 Jul 1949
William Henry Simcox
b. 4 Jul 1861 d. 31 May 1950
12
Glenn Raymond Simcox
[1.1.4.1.1.1.3.7.5.1.2.1]
b. 12 Sep 1887
12
Merle Marie Simcox
[1.1.4.1.1.1.3.7.5.1.2.2]
b. 23 Feb 1890 [
=>
]
11
Ida May Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.5.1.3]
d. Bef 1908
+
Osbert D Polley
b. Sep 1859 d. 1935
10
William R Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.5.2]
b. 1831 d. 26 Feb 1889
Lucy Ann Clark
b. 16 Dec 1836 d. 21 Feb 1903
11
Edith Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.5.2.1]
b. 1868
11
Melvin Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.5.2.2]
b. 1869 d. 1870
11
Eva L Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.5.2.3]
b. Mar 1875
10
John Thompson Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.5.3]
b. 25 May 1833 d. 2 Apr 1914
Louisa Clark
b. 18 Nov 1835 d. 23 Jan 1918
11
Jay Clark Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.5.3.1]
b. Aug 1856 d. 26 Aug 1937
Maria E Highland
b. Nov 1856 d. 24 Apr 1943
12
Freddie Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.5.3.1.1]
b. 19 Sep 1881 d. 24 Feb 1883
12
Frank E Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.5.3.1.2]
b. Mar 1885
12
Harrold J Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.5.3.1.3]
b. Mar 1897
11
Leonard E Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.5.3.2]
b. Jun 1860 d. 3 Jan 1927
+
Georgiana P DeLoss
b. 22 Apr 1865 d. 14 Dec 1920
10
Emory J Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.5.4]
b. Jul 1836 d. 8 Mar 1926
Jane Ann Van Sickle
b. 20 Mar 1838
11
Ella L Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.5.4.1]
b. Abt 1863
+
Robert Alexander Calhoun
b. 29 Apr 1864
11
Clarence Emery Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.5.4.2]
b. Jan 1870
Maud Maria Logan
b. Abt 1878
12
Ruth M Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.5.4.2.1]
b. 26 Mar 1903
11
Alma Edna Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.5.4.3]
b. May 1880
+
Samuel J Logan
b. Abt 1879
+
Helen Rebecca Sherman
10
Finley E Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.5.5]
b. Abt 1841
Maria Higby
b. Abt 1843 d. Bef 1910
11
Marion Arthur Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.5.5.1]
b. 13 Nov 1868 d. Aft 28 Apr 1930
Anna Day Hatch
b. 31 Oct 1868 d. 30 Oct 1931
12
Lela Haidee Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.5.5.1.1]
b. 17 Mar 1891
12
Leon Eugene Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.5.5.1.2]
b. 27 Aug 1894 d. Jan 1969
12
Frank Hatch Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.5.5.1.3]
b. 9 Jun 1897 d. Jun 1983
11
Delbert Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.5.5.2]
b. Abt 1878
Hannah Sherman
10
Mary Isabelle Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.5.6]
b. 7 Jun 1853 d. 9 Dec 1935
Howard Spurgeon Green
b. 25 Aug 1850 d. 24 Jan 1912
11
Roy C Green
[1.1.4.1.1.1.3.7.5.6.1]
b. 3 Nov 1879 d. Jul 1955
Maude Wettrich
b. Oct 1880 d. Jun 1938
12
Richard C Green
[1.1.4.1.1.1.3.7.5.6.1.1]
b. 3 Oct 1910 d. Apr 1967
11
Leonard Benson Green
[1.1.4.1.1.1.3.7.5.6.2]
b. 10 Nov 1882 d. 24 Jul 1947
+
May Effie Chapman
b. 18 May 1882 d. 22 Aug 1943
11
Helen Ione Green
[1.1.4.1.1.1.3.7.5.6.3]
b. 23 Oct 1893
9
Phila Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.6]
b. 27 Jul 1802
Charles Warner
b. Abt 1800
10
Susan Warner
[1.1.4.1.1.1.3.7.6.1]
b. 1828
10
Mary Warner
[1.1.4.1.1.1.3.7.6.2]
b. 1830
10
Harriet Warner
[1.1.4.1.1.1.3.7.6.3]
b. 1832
9
Calista Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.7]
b. 2 Jun 1804 d. 15 Sep 1882
Jacob Conklin
b. 19 Sep 1798 d. 1 Nov 1884
10
Sarah Conklin
[1.1.4.1.1.1.3.7.7.1]
b. 1828
10
Edward Conklin
[1.1.4.1.1.1.3.7.7.2]
b. Abt 1828
10
Sory Ann Conklin
[1.1.4.1.1.1.3.7.7.3]
b. 1831 d. 7 Feb 1832
10
Benson Conklin
[1.1.4.1.1.1.3.7.7.4]
b. May 1833
Tina Ann Roseboone
b. 1838
11
Ella Mary Abbott Conklin
[1.1.4.1.1.1.3.7.7.4.1]
b. 16 May 1856
11
Frank B Conklin
[1.1.4.1.1.1.3.7.7.4.2]
b. 1857
11
Gilbert Conklin
[1.1.4.1.1.1.3.7.7.4.3]
b. 1859
11
Charles Conklin
[1.1.4.1.1.1.3.7.7.4.4]
b. 1860 d. 6 Sep 1865
11
Lizzie Conklin
[1.1.4.1.1.1.3.7.7.4.5]
b. 1862
11
Kittie E Conklin
[1.1.4.1.1.1.3.7.7.4.6]
b. 1872
+
Della J Walsh
b. Feb 1838
10
John Conklin
[1.1.4.1.1.1.3.7.7.5]
b. 1835 d. 25 Oct 1835
10
Maria Conklin
[1.1.4.1.1.1.3.7.7.6]
b. 1837 d. 1850
10
Daughter Conklin
[1.1.4.1.1.1.3.7.7.7]
b. 1840 d. 1840
10
Eugene Conklin
[1.1.4.1.1.1.3.7.7.8]
b. 1841 d. 14 Apr 1912
Harriet Ann Van Etten
b. 1845 d. 2 Jun 1932
11
Nellie V Conklin
[1.1.4.1.1.1.3.7.7.8.1]
b. 1872 d. 16 Sep 1893
11
Mary F Conklin
[1.1.4.1.1.1.3.7.7.8.2]
b. 1881 d. 25 Aug 1960
+
Carlton A Church
b. 1866 d. 1 Mar 1948
10
Daughter Conklin
[1.1.4.1.1.1.3.7.7.9]
b. 1843 d. 3 Mar 1843
10
Lewis Smith Conklin
[1.1.4.1.1.1.3.7.7.10]
b. Nov 1845 d. 28 Feb 1905
Persis Wiggins
b. May 1848 d. 4 May 1920
11
Florence Conklin
[1.1.4.1.1.1.3.7.7.10.1]
b. 1877 bur. 14 Aug 1894
11
Anna Bessie Conklin
[1.1.4.1.1.1.3.7.7.10.2]
b. Apr 1877
11
Don J Conklin
[1.1.4.1.1.1.3.7.7.10.3]
b. Oct 1880
11
Sarah C Conklin
[1.1.4.1.1.1.3.7.7.10.4]
b. Sep 1888
+
Donald MacCluer
b. 28 May 1885 d. 15 Nov 1972
10
Annette Conklin
[1.1.4.1.1.1.3.7.7.11]
b. 1848 d. 22 Jun 1848
9
Ruth Wheelock Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.8]
b. 21 Sep 1807
William J Vermilyea
b. 7 Jul 1803 d. 30 Jun 1879
10
Francis Arvilla Vermilyea
[1.1.4.1.1.1.3.7.8.1]
b. 19 Apr 1830 d. 19 Nov 1915
Isaac Fuller Camp
b. 11 Feb 1823 d. 10 Aug 1890
11
Edwin L Camp
[1.1.4.1.1.1.3.7.8.1.1]
b. 13 Mar 1851
11
Ida M Vermilyea
[1.1.4.1.1.1.3.7.8.1.2]
b. 8 Mar 1857
11
Hanna Ruth Camp
[1.1.4.1.1.1.3.7.8.1.3]
b. 23 Apr 1859
11
Albert E Camp
[1.1.4.1.1.1.3.7.8.1.4]
b. Nov 1862
11
Mary A Camp
[1.1.4.1.1.1.3.7.8.1.5]
b. 1864
11
William Whitney Camp
[1.1.4.1.1.1.3.7.8.1.6]
b. 5 Feb 1867
10
Emily Benson Vermilyea
[1.1.4.1.1.1.3.7.8.2]
b. 6 Dec 1831 d. Jun 1902
William Henry Myers
b. 1827
11
William Franklin Myers
[1.1.4.1.1.1.3.7.8.2.1]
b. 1855
11
Selina Delphenie Myers
[1.1.4.1.1.1.3.7.8.2.2]
b. 1857
11
Elizabeth Lorma Myers
[1.1.4.1.1.1.3.7.8.2.3]
b. 1860
11
Henrietta Lorma Myers
[1.1.4.1.1.1.3.7.8.2.4]
b. 1862
11
Harriet Benson Myers
[1.1.4.1.1.1.3.7.8.2.5]
b. 1869
11
Gertrude Lucinia Myers
[1.1.4.1.1.1.3.7.8.2.6]
b. 1874
10
Sidney Smith Vermilyea
[1.1.4.1.1.1.3.7.8.3]
b. 27 Oct 1835 d. 22 Dec 1929
Amanda Fluke
b. 31 May 1842 d. 31 Mar 1937
11
Owen C Vermilyea
[1.1.4.1.1.1.3.7.8.3.1]
b. 20 Jul 1864 d. 1919
Verna Woodworth
b. 30 Jul 1864
12
Gladys Vermilyea
[1.1.4.1.1.1.3.7.8.3.1.1]
b. 1896
12
Percy Vermilyea
[1.1.4.1.1.1.3.7.8.3.1.2]
b. 1896 d. 1896
11
Henry Arthur Vermilyea
[1.1.4.1.1.1.3.7.8.3.2]
b. 12 Mar 1867
Emma Rebecca Nelson
b. 28 Nov 1872
12
Leo Wilson Vermilyea
[1.1.4.1.1.1.3.7.8.3.2.1]
b. 14 Apr 1891
12
John Victor Vermilyea
[1.1.4.1.1.1.3.7.8.3.2.2]
b. 25 Feb 1893 d. 6 Dec 1988
12
Bertha Blanche Vermilyea
[1.1.4.1.1.1.3.7.8.3.2.3]
b. 27 Mar 1895
12
Harold James Vermilyea
[1.1.4.1.1.1.3.7.8.3.2.4]
b. 15 Aug 1900 d. 1986
11
Bert Vermilyea
[1.1.4.1.1.1.3.7.8.3.3]
b. 4 Dec 1868
Lillian Drain
b. 25 Jan 1868 d. 31 Jul 1898
12
Ruth Vermilyea
[1.1.4.1.1.1.3.7.8.3.3.1]
b. 12 Apr 1894
12
Carl Vermilyea
[1.1.4.1.1.1.3.7.8.3.3.2]
b. 25 Aug 1895
12
Clarence Vermilyea
[1.1.4.1.1.1.3.7.8.3.3.3]
b. 1897
11
Charles E Vermilyea
[1.1.4.1.1.1.3.7.8.3.4]
b. 15 Jan 1871
Goldie Fausey
b. 22 Jul 1871
12
Harold Vermilyea
[1.1.4.1.1.1.3.7.8.3.4.1]
b. 1902
12
Margery Vermilyea
[1.1.4.1.1.1.3.7.8.3.4.2]
b. Abt 1904
11
Edgar L Vermilyea
[1.1.4.1.1.1.3.7.8.3.5]
b. 12 Oct 1874
Hester Rosana Mincks
b. 19 Jan 1874 d. 11 Mar 1947
12
Donald Mincks Vermilyea
[1.1.4.1.1.1.3.7.8.3.5.1]
b. 22 Apr 1900
12
Kathryne Vermilyea
[1.1.4.1.1.1.3.7.8.3.5.2]
b. 10 Sep 1903
11
Mary A Vermilyea
[1.1.4.1.1.1.3.7.8.3.6]
b. 2 Feb 1880 d. Abt 1981
10
Elkanah Benson Vermilyea
[1.1.4.1.1.1.3.7.8.4]
b. 9 Sep 1837 d. 31 May 1838
10
Chauncey Vermilyea
[1.1.4.1.1.1.3.7.8.5]
b. 25 Mar 1839 d. 16 Jun 1863
10
Eliza Prudence Vermilyea
[1.1.4.1.1.1.3.7.8.6]
b. 4 Apr 1842 d. 1923
James Tytler Johnstone
c. 18 Oct 1840 d. 1913
11
Harry Vermilyea Johnstone
[1.1.4.1.1.1.3.7.8.6.1]
b. 1872
11
Elizabeth Winifred Johnstone
[1.1.4.1.1.1.3.7.8.6.2]
b. 1873
11
James Charles Johnstone
[1.1.4.1.1.1.3.7.8.6.3]
b. 1875
11
John Harvey Johnstone
[1.1.4.1.1.1.3.7.8.6.4]
b. 1877
11
James Benson Johnstone
[1.1.4.1.1.1.3.7.8.6.5]
b. 1880
11
Donald Denny Johnstone
[1.1.4.1.1.1.3.7.8.6.6]
b. 1884
10
John Benson Vermilyea
[1.1.4.1.1.1.3.7.8.7]
b. 26 May 1844
+
Mary Elizabeth Frizzle
b. 1848
10
Albert Gallatin Vermilyea
[1.1.4.1.1.1.3.7.8.8]
b. 15 Sep 1846
Samantha Sophia Crawford
b. 1850
11
Lillie Alice Vermilyea
[1.1.4.1.1.1.3.7.8.8.1]
b. 26 Sep 1872
+
Andrew James Gregg
b. 2 May 1863 d. 29 Aug 1944
11
Carl Crawford Vermilyea
[1.1.4.1.1.1.3.7.8.8.2]
b. 1 Feb 1874
Sarah May Fair
b. 1877
12
Fairy Albertine Vermilyea
[1.1.4.1.1.1.3.7.8.8.2.1]
b. 20 Mar 1899
11
Daughter Vermilyea
[1.1.4.1.1.1.3.7.8.8.3]
b. 1877 d. 1877
9
Sarah Elizabeth Benson
[1.1.4.1.1.1.3.7.9]
b. 1 Jul 1809 d. 20 Jul 1888
Leicester Dodge
b. 28 Apr 1808 d. 5 Sep 1843
10
Ermina P Dodge
[1.1.4.1.1.1.3.7.9.1]
b. 14 Feb 1831
+
Rufus Moe
10
Henry Benson Dodge
[1.1.4.1.1.1.3.7.9.2]
b. 3 Oct 1832 d. 16 Feb 1914
Sally Betsey Howard
b. 27 Dec 1834 d. 15 Dec 1919
11
Emaline Elizabeth Dodge
[1.1.4.1.1.1.3.7.9.2.1]
b. 29 Dec 1861 d. 1932
11
Ezra Leicester Dodge
[1.1.4.1.1.1.3.7.9.2.2]
b. 22 Nov 1863 d. 3 Dec 1950
+
Elizabeth Cline
b. 1866
11
Benson Henry Dodge
[1.1.4.1.1.1.3.7.9.2.3]
b. 15 Jan 1867 d. 25 Jun 1931
Cora Ethel Hendrickson
b. 1869
12
Violet Dodge
[1.1.4.1.1.1.3.7.9.2.3.1]
b. May 1897
11
Susan Louisa Dodge
[1.1.4.1.1.1.3.7.9.2.4]
b. 28 May 1868 d. 8 Oct 1913
11
Hattie Blanche Dodge
[1.1.4.1.1.1.3.7.9.2.5]
b. 25 Jun 1870 d. 1944
Almon G Libey
b. Nov 1868 d. 1940
12
Alta Inez Libey
[1.1.4.1.1.1.3.7.9.2.5.1]
b. 6 Nov 1892 d. 15 Sep 1967 [
=>
]
12
Chester B Libey
[1.1.4.1.1.1.3.7.9.2.5.2]
b. 16 Dec 1893 d. 8 Aug 1953
12
Arlie G Libey
[1.1.4.1.1.1.3.7.9.2.5.3]
b. 30 Jun 1895 d. 27 Dec 1971 [
=>
]
10
Flora Elizabeth Dodge
[1.1.4.1.1.1.3.7.9.3]
b. 6 Nov 1834
+
Horace Richards
10
Sarah Janette Dodge
[1.1.4.1.1.1.3.7.9.4]
b. 20 Sep 1836
10
Calista Augusta Dodge
[1.1.4.1.1.1.3.7.9.5]
b. 23 Nov 1838 d. 29 Aug 1884
+
William Alexander Gunsaullus
b. 15 Jul 1835 d. 27 Aug 1871
10
Caroline Emelia Dodge
[1.1.4.1.1.1.3.7.9.6]
b. 30 Aug 1841 d. 7 Dec 1913
William Hadcill Carr
b. 13 Dec 1836 d. 19 Mar 1909
11
Florence A Carr
[1.1.4.1.1.1.3.7.9.6.1]
b. 22 Jan 1864 d. 17 Feb 1904
+
John P Hight
b. 1853 d. 1936
11
Arthur Elmer Carr
[1.1.4.1.1.1.3.7.9.6.2]
b. 19 Jun 1867 d. 20 Oct 1943
+
Helen M Maloy
b. Nov 1883 d. Oct 1961
10
Lester Lewis Dodge
[1.1.4.1.1.1.3.7.9.7]
b. 30 Oct 1843
7
Eleazar Wheelock
[1.1.4.1.1.1.4]
b. 31 Mar 1734 d. 31 Aug 1747
6
Huldah Wheelock
[1.1.4.1.1.2]
b. 17 Aug 1710 d. 1813
6
Jonathan Wheelock
[1.1.4.1.1.3]
b. 21 Jul 1713 d. 26 Jul 1783
6
Paul Wheelock
[1.1.4.1.1.4]
b. 13 Jan 1715 d. 16 May 1776
6
Silas Wheelock
[1.1.4.1.1.5]
b. 11 Mar 1717 d. 22 Apr 1793
6
David Wheelock
[1.1.4.1.1.6]
b. 18 Jan 1720 d. 5 Jan 1789
6
Peter Wheelock
[1.1.4.1.1.7]
b. 23 Jul 1724 d. 18 Feb 1802
5
Grace Thayer
[1.1.4.1.2]
b. 20 Dec 1684 d. 28 Aug 1720
5
Hezekiah Thayer
[1.1.4.1.3]
b. 8 Feb 1686 d. 13 Jan 1689
5
Deborah Thayer
[1.1.4.1.4]
b. 4 Nov 1687 d. 8 Oct 1733
5
Johnathan Thayer
[1.1.4.1.5]
b. 8 Dec 1690 d. 27 Apr 1747
4
John French
[1.1.4.2]
b. 28 Feb 1641 d. 6 Aug 1699
4
Thomas French
[1.1.4.3]
b. 10 Jul 1643 d. 28 Aug 1656
4
Mary French
[1.1.4.4]
b. 1646 d. 1672
Samuel Poole
b. 1645 d. 30 Apr 1669
5
Alice Poole
[1.1.4.4.1]
b. 20 Nov 1668 d. 8 Dec 1745
Captain Thomas Thayer
b. 14 Feb 1663 d. 1 May 1738
6
Mary Thayer
[1.1.4.4.1.1]
b. 16 Jan 1689 d. 26 Aug 1720
6
Thomas Thayer
[1.1.4.4.1.2]
b. 14 Jan 1694 d. 10 Feb 1761
Ruth Darling
b. 20 Sep 1695 d. 8 Dec 1776
7
Priscilla Thayer
[1.1.4.4.1.2.1]
b. 6 Jun 1717 d. Aft 1761
Lieutenant Moses Taft
b. 30 Jan 1712 d. 16 Jul 1778
8
Lieutenant Abner Taft
[1.1.4.4.1.2.1.1]
b. 28 Dec 1736 d. 30 May 1809
Tryal White
b. 8 May 1737 d. 14 Jun 1814
9
Oliver Taft
[1.1.4.4.1.2.1.1.1]
b. 1 May 1758 d. 16 Jul 1775
9
Moses Taft
[1.1.4.4.1.2.1.1.2]
b. 29 Sep 1760 d. 4 Dec 1848
Judith Cummings
b. 26 Nov 1766 d. 26 Nov 1816
10
Nancy Taft
[1.1.4.4.1.2.1.1.2.1]
b. 10 Mar 1787
10
Samuel Taft
[1.1.4.4.1.2.1.1.2.2]
b. 24 Sep 1790 d. 11 Oct 1863
10
Lucy Taft
[1.1.4.4.1.2.1.1.2.3]
b. 24 Apr 1795 d. 21 Jun 1847
10
Newell Taft
[1.1.4.4.1.2.1.1.2.4]
b. 28 Jul 1804 d. 4 Nov 1873
Hannah G Taft
b. 18 May 1802 d. 8 Jan 1843
11
Albert Taft
[1.1.4.4.1.2.1.1.2.4.1]
b. 28 Aug 1823 d. Aft 1874
Sally L Bartlett
b. 14 Oct 1827 d. 1 Sep 1874
12
Charles B Taft
[1.1.4.4.1.2.1.1.2.4.1.1]
b. Feb 1854 d. 23 Sep 1854
12
Hannah L Taft
[1.1.4.4.1.2.1.1.2.4.1.2]
b. 5 Feb 1856
11
Marcy Taft
[1.1.4.4.1.2.1.1.2.4.2]
b. Mar 1829 d. 12 Apr 1830
11
Charles M Taft
[1.1.4.4.1.2.1.1.2.4.3]
b. Jan 1843 d. 7 Dec 1843
10
Sylvia Taft
[1.1.4.4.1.2.1.1.2.5]
b. 23 Aug 1810 d. 3 Aug 1816
9
Mary Taft
[1.1.4.4.1.2.1.1.3]
b. 12 Oct 1767 d. 18 Aug 1775
9
Webb Taft
[1.1.4.4.1.2.1.1.4]
b. 26 Mar 1772 d. 21 Apr 1842
Lucy Taft
b. 9 Jun 1774 d. 14 Mar 1846
10
Lucinda Taft
[1.1.4.4.1.2.1.1.4.1]
b. 22 Nov 1793
10
Jason Taft
[1.1.4.4.1.2.1.1.4.2]
b. 5 Jun 1796 d. 25 Oct 1861
9
Trial T Taft
[1.1.4.4.1.2.1.1.5]
b. 13 Apr 1777 d. 18 Aug 1815
8
James Taft
[1.1.4.4.1.2.1.2]
b. 9 Apr 1738 d. 14 Jan 1826
Esther Taft
b. 9 Jan 1747 d. 3 Feb 1834
9
Lucy Taft
[1.1.4.4.1.2.1.2.1]
b. 22 Nov 1769 d. 29 Jul 1845
Ebenezer Winslow
b. 21 Jan 1772 d. 21 Feb 1841
10
Albert Winslow
[1.1.4.4.1.2.1.2.1.1]
b. 24 Jul 1797
Sarah Gardner
b. 25 Jul 1803 d. 23 Sep 1840
11
Martha Maria Winslow
[1.1.4.4.1.2.1.2.1.1.1]
b. 12 Mar 1826 d. 16 Mar 1842
11
Preston Willard Winslow
[1.1.4.4.1.2.1.2.1.1.2]
b. 13 Nov 1828
Lucy Weatherbee
b. 16 Jul 1829 d. 8 Nov 1859
12
Mary Charlena Winslow
[1.1.4.4.1.2.1.2.1.1.2.1]
b. 22 Apr 1858
+
Maria Fuller
b. 12 Apr 1841
11
Mary Augusta Allen Winslow
[1.1.4.4.1.2.1.2.1.1.3]
b. 14 Sep 1831
+
Charles Warner
b. Abt 1830
11
John Alvin Winslow
[1.1.4.4.1.2.1.2.1.1.4]
b. 3 Jul 1834
11
Jasper Ross Winslow
[1.1.4.4.1.2.1.2.1.1.5]
b. 7 Apr 1837 d. 25 Oct 1841
11
Sarah Adaline Winslow
[1.1.4.4.1.2.1.2.1.1.6]
b. 20 Dec 1839 d. 9 Dec 1841
Sylvia Babbit
b. 27 Jan 1814
11
Jasper Albert Winslow
[1.1.4.4.1.2.1.2.1.1.7]
b. 15 Apr 1842 d. 14 Oct 1864
10
Claramond Winslow
[1.1.4.4.1.2.1.2.1.2]
b. 10 Feb 1799 d. 27 Apr 1834
John Hathaway
b. 22 May 1797
11
Son Hathaway
[1.1.4.4.1.2.1.2.1.2.1]
b. Apr 1828 d. 14 Apr 1828
11
Francis Ebenezer Hathaway
[1.1.4.4.1.2.1.2.1.2.2]
b. 9 Mar 1829
Lydia Carter
b. 24 Mar 1832
12
Hattie Carter Hathaway
[1.1.4.4.1.2.1.2.1.2.2.1]
b. 10 Jan 1865 d. 30 Oct 1958 [
=>
]
11
Catherine Elizabeth Hathaway
[1.1.4.4.1.2.1.2.1.2.3]
b. 18 Feb 1833
11
George H Hathaway
[1.1.4.4.1.2.1.2.1.2.4]
b. 13 Aug 1839
Abigail F Pomeroy
b. Abt 1843 d. 9 Feb 1891
12
Charles Edward Hathaway
[1.1.4.4.1.2.1.2.1.2.4.1]
b. 23 Oct 1866
10
Alvin Winslow
[1.1.4.4.1.2.1.2.1.3]
b. 27 Aug 1802 d. 9 Oct 1803
10
Paulina Maria Winslow
[1.1.4.4.1.2.1.2.1.4]
b. 27 May 1805
+
Austin Crosby
b. 10 Mar 1805 d. 13 Jun 1868
10
Lucy Emma Winslow
[1.1.4.4.1.2.1.2.1.5]
b. 17 Feb 1808 d. 20 Feb 1870
+
Matthew Henry McClary
b. 10 Mar 1801
9
Zilpha Taft
[1.1.4.4.1.2.1.2.2]
b. 1 Jul 1772 d. 24 Feb 1848
Nathan Fisher
b. 25 Jun 1770 d. 21 Mar 1847
10
Elias Fisher
[1.1.4.4.1.2.1.2.2.1]
b. 10 Jul 1796
10
Elise Fisher
[1.1.4.4.1.2.1.2.2.2]
b. 10 Jul 1796
10
Josiah Fisher
[1.1.4.4.1.2.1.2.2.3]
b. 26 Feb 1798 d. 11 Apr 1799
10
Josiah Fisher
[1.1.4.4.1.2.1.2.2.4]
b. 1 Dec 1801
10
Rachel Adaline Fisher
[1.1.4.4.1.2.1.2.2.5]
b. 29 Jan 1804
+
Moses Daniels Southwick
10
Mary Caroline Fisher
[1.1.4.4.1.2.1.2.2.6]
b. 22 Mar 1806
10
Nathan Fisher
[1.1.4.4.1.2.1.2.2.7]
b. 21 Mar 1811
9
Irena Taft
[1.1.4.4.1.2.1.2.3]
b. 25 Oct 1774 d. 29 May 1790
9
Ezekial Taft
[1.1.4.4.1.2.1.2.4]
b. 21 Jan 1777 d. 24 Apr 1841
+
Olive Thayer
b. 10 Aug 1782 d. 1865
9
James Taft
[1.1.4.4.1.2.1.2.5]
b. 13 Jun 1780
9
Luke Taft
[1.1.4.4.1.2.1.2.6]
b. 3 Jun 1783
Nancy Wood
b. 6 Feb 1787 d. 6 May 1859
10
Clarissa Wood Taft
[1.1.4.4.1.2.1.2.6.1]
b. 3 May 1810 d. 1889
Caleb Chapin
b. 6 Feb 1806 d. 27 Sep 1883
11
Eunice Chapin
[1.1.4.4.1.2.1.2.6.1.1]
b. 1 May 1832 d. 29 Sep 1920
Samuel Mills Capron
b. 15 May 1832 d. 4 Jan 1874
12
Helen Maria Capron
[1.1.4.4.1.2.1.2.6.1.1.1]
b. 26 Mar 1858 d. 6 Jan 1863
12
Alice Louise Capron
[1.1.4.4.1.2.1.2.6.1.1.2]
b. 26 Mar 1862 d. 13 Jan 1863
12
Clara D Capron
[1.1.4.4.1.2.1.2.6.1.1.3]
b. 4 Aug 1864
12
Bertha C Capron
[1.1.4.4.1.2.1.2.6.1.1.4]
b. 16 Mar 1868 [
=>
]
12
William Cargill Capron
[1.1.4.4.1.2.1.2.6.1.1.5]
b. 27 Jul 1869 [
=>
]
11
Ezra Wood Chapin
[1.1.4.4.1.2.1.2.6.1.2]
b. 7 Jun 1836 d. 31 Mar 1909
Ellen Frances Cooper
b. 30 Dec 1835
12
Janet Chapin
[1.1.4.4.1.2.1.2.6.1.2.1]
b. 28 May 1870
11
Edwin Chapin
[1.1.4.4.1.2.1.2.6.1.3]
b. 7 Jun 1836 d. 27 Sep 1836
10
Moses Taft
[1.1.4.4.1.2.1.2.6.2]
b. 26 Jan 1812
Sylvia Ann Wheelock
b. 3 Feb 1815 d. 3 Oct 1855
11
Sarah Wood Taft
[1.1.4.4.1.2.1.2.6.2.1]
b. 6 Jan 1838
Lewis Henry Murdock
b. 17 Mar 1835 d. 25 Mar 1916
12
Herbert Taft Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.6.2.1.1]
b. 11 Sep 1865 d. 29 Oct 1916 [
=>
]
12
Edgar Wheelock Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.6.2.1.2]
b. 1 Feb 1869 d. 13 Jun 1904
11
Susan Hortense Taft
[1.1.4.4.1.2.1.2.6.2.2]
b. 5 Jan 1843
11
Luke Herbert Taft
[1.1.4.4.1.2.1.2.6.2.3]
b. 9 Nov 1846
+
Helen Eugenia Bechet
10
Sarah Taft
[1.1.4.4.1.2.1.2.6.3]
b. 15 Jan 1815 d. 24 Dec 1898
Amariah Albee Wood
b. 2 Nov 1802 d. 14 Jun 1871
11
Sarah A Wood
[1.1.4.4.1.2.1.2.6.3.1]
b. May 1837 d. 26 Sep 1837
11
Samuel Taft Wood
[1.1.4.4.1.2.1.2.6.3.2]
b. 4 Oct 1841 d. Jun 1925
+
Olive DeWilton Seagrave
b. 17 Jul 1842 d. 7 Aug 1862
Mary E Rawson
b. 11 Sep 1845
12
Eva Gertrude Wood
[1.1.4.4.1.2.1.2.6.3.2.1]
b. 29 May 1865
12
Merritt D Wood
[1.1.4.4.1.2.1.2.6.3.2.2]
b. 2 Sep 1873
11
Mary Baylies Wood
[1.1.4.4.1.2.1.2.6.3.3]
b. 29 Apr 1847 d. 9 Sep 1847
11
Anna I Wood
[1.1.4.4.1.2.1.2.6.3.4]
b. 18 Aug 1848 d. 1919
10
Irene Taft
[1.1.4.4.1.2.1.2.6.4]
b. 19 Sep 1816 d. 26 Jan 1900
Silas Mandeville Wheelock
b. 11 Nov 1817 d. 18 Oct 1901
11
Ellen Maria Wheelock
[1.1.4.4.1.2.1.2.6.4.1]
b. 2 Sep 1842 d. 1871
11
Eugene Augustus Wheelock
[1.1.4.4.1.2.1.2.6.4.2]
b. 15 Feb 1846 d. 14 Sep 1912
Sarah Smith Taft
b. 17 Apr 1846
12
Silas Mandeville Wheelock
[1.1.4.4.1.2.1.2.6.4.2.1]
b. 10 Mar 1871 d. 22 Jun 1937 [
=>
]
12
Ellen Maria Wheelock
[1.1.4.4.1.2.1.2.6.4.2.2]
b. 20 Mar 1873 d. 12 Mar 1954
12
Mary Taft Wheelock
[1.1.4.4.1.2.1.2.6.4.2.3]
b. 8 Aug 1875 d. 21 Jul 1957
12
Irene Taft Wheelock
[1.1.4.4.1.2.1.2.6.4.2.4]
b. 7 Apr 1881 d. 2 Jan 1963
12
Henry Arnold Wheelock
[1.1.4.4.1.2.1.2.6.4.2.5]
b. 27 Aug 1883 d. 12 Jul 1954
+
Caroline Harper
11
Alice Augusta Wheelock
[1.1.4.4.1.2.1.2.6.4.3]
b. 22 Jan 1849 d. Sep 1891
11
Arthur Wheelock
[1.1.4.4.1.2.1.2.6.4.4]
b. 26 Mar 1851 d. 23 Sep 1927
Emogene Atchinson
b. 22 Sep 1851 d. 12 Apr 1898
12
Stanley H Wheelock
[1.1.4.4.1.2.1.2.6.4.4.1]
b. 15 Jul 1879 [
=>
]
12
Annie Atchinan Wheelock
[1.1.4.4.1.2.1.2.6.4.4.2]
b. 15 Jan 1887 d. 5 Oct 1918
+
Harriet E Fuller
b. 1845
11
Henry Wheelock
[1.1.4.4.1.2.1.2.6.4.5]
b. 14 Jan 1857 d. 13 Nov 1881
+
Jane Goulding Taft
b. 12 Oct 1856 d. 20 Jan 1931
10
Chloe M Taft
[1.1.4.4.1.2.1.2.6.5]
b. 5 Feb 1823
Luke Southwick Farnham
b. 20 Jan 1817 d. 23 Aug 1883
11
Elizabeth Southwick Farnham
[1.1.4.4.1.2.1.2.6.5.1]
b. 1852
+
Jerome Prentiss
11
Ella Frances Farnham
[1.1.4.4.1.2.1.2.6.5.2]
b. 1855
11
Moses Taft Farnham
[1.1.4.4.1.2.1.2.6.5.3]
b. 1858
11
Walter James Farnham
[1.1.4.4.1.2.1.2.6.5.4]
b. 1862
10
James Taft
[1.1.4.4.1.2.1.2.6.6]
b. 1830
9
Esther Taft
[1.1.4.4.1.2.1.2.7]
b. 5 Aug 1786 d. 10 Aug 1858
Fuller Murdock
b. 17 Feb 1781 d. 8 Nov 1857
10
Philena Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.1]
b. 26 Aug 1807 d. 30 Jun 1835
Samuel Merriam
b. Abt 1803
11
George Nison Merriam
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.1.1]
b. 26 Dec 1834 d. 19 Nov 1903
Ellen Jane Pickering
b. 27 Mar 1836 d. 15 Jan 1911
12
Josephine Louisa Merriam
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.1.1.1]
b. 29 Oct 1859 d. 14 Mar 1949
12
Nellie Pickering Merriam
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.1.1.2]
b. 26 Feb 1870 d. 20 Nov 1887
12
Flora N. Merriam
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.1.1.3]
b. 31 Mar 1872
10
Abba Eliza Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.2]
b. 13 Nov 1808 d. 4 Apr 1834
Pemberton Brown
b. 11 Oct 1801 d. 30 Mar 1870
11
Tarissa Gregory Brown
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.2.1]
b. 3 Oct 1828 d. 12 Oct 1914
John Conley Fisher
b. 25 May 1818 d. 1 Dec 1898
12
Paulina Agnes Fisher
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.2.1.1]
b. 2 Dec 1848 d. 2 Oct 1850
12
Elizabeth B Fisher
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.2.1.2]
b. 25 Jun 1853 d. 5 Nov 1933 [
=>
]
12
Alonzo Pemberton Fisher
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.2.1.3]
b. 11 Dec 1855 d. 21 Feb 1937 [
=>
]
12
Ida H. Fisher
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.2.1.4]
b. 1858
12
Lillian L. Fisher
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.2.1.5]
b. 2 Oct 1860
12
Malvern Adelbert Fisher
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.2.1.6]
b. 30 Mar 1863 [
=>
]
12
Georgene Fisher Gardner
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.2.1.7]
b. 12 Oct 1864 d. 17 Oct 1942 [
=>
]
12
Myrtella Fisher
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.2.1.8]
b. 30 Jul 1867
11
Josephine Brown
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.2.2]
b. 29 Jan 1830 d. 16 Jan 1895
William Brainerd Cadwell
b. 2 Sep 1832 d. 1870
12
Abbie Flora Cadwell
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.2.2.1]
b. 19 Oct 1854 d. 24 Sep 1937 [
=>
]
12
Etola Florence Cadwell
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.2.2.2]
b. 16 Jul 1857 d. 27 Dec 1937 [
=>
]
11
Adin Ballou Brown
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.2.3]
b. 14 Nov 1831 d. 19 Apr 1880
11
Edin Ballow Brown
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.2.4]
b. 14 Nov 1831
11
Abba Eliza Brown
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.2.5]
b. 30 Jun 1833 d. 19 Oct 1914
Abiel Copelin
b. 22 Jul 1834 d. 8 Jul 1907
12
Arthur A. Copelin
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.2.5.1]
b. 1859 d. 3 May 1884
12
Herbert A. Copelin
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.2.5.2]
b. 31 May 1867 d. 14 Aug 1867
10
Moses Taft Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.3]
b. 12 Sep 1810 d. 7 Feb 1883
Dorinda Wood Grout
b. 19 Aug 1810 d. 15 Jan 1888
11
Cyrus Grout Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.3.1]
b. 16 Jun 1833 d. 7 Jun 1913
Sarah Ann Aldrich
b. 3 Apr 1831 d. 1 Mar 1902
12
Son Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.3.1.1]
b. 20 May 1856 d. 20 May 1856
12
Lillian A Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.3.1.2]
b. 17 Apr 1857 d. 7 Dec 1927
12
Bertha Aldrich Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.3.1.3]
b. 15 May 1872 d. 12 Nov 1940
11
Lewis Henry Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.3.2]
b. 17 Mar 1835 d. 25 Mar 1916
Sarah Wood Taft
b. 6 Jan 1838
12
Herbert Taft Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.3.2.1]
b. 11 Sep 1865 d. 29 Oct 1916 [
=>
]
12
Edgar Wheelock Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.3.2.2]
b. 1 Feb 1869 d. 13 Jun 1904
11
Sarah A Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.3.3]
b. Jul 1837 d. 1 Sep 1838
11
Lucius Walter Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.3.4]
b. 11 Apr 1846 d. 1 Jul 1867
11
Samuel Justin Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.3.5]
b. 13 May 1848 d. 11 May 1910
Mary Brown
b. 1843 d. 11 Apr 1920
12
Lena D M Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.3.5.1]
b. 5 Mar 1871 d. 30 Jun 1871
12
Lewis F Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.3.5.2]
b. 18 May 1873
11
Lyman Wood Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.3.6]
b. 26 Dec 1853 d. Bef 1900
Elizabeth Ann Snowling
b. 16 Jan 1860 d. 17 Aug 1918
12
May A. Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.3.6.1]
b. 1881
12
Minnie Idella Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.3.6.2]
b. 19 Jun 1884
10
John Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.4]
b. 9 Sep 1812 d. 13 Sep 1837
10
Charles Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.5]
b. 11 Feb 1815 d. 6 Aug 1869
Mary Ann Weightman
b. 3 Apr 1823 d. 11 May 1895
11
Charles W Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.5.1]
b. 4 Mar 1854 d. 5 Mar 1916
Abba Loretta Wardwell
b. 29 Jan 1849 d. 12 Jun 1929
12
Leroy Eugene Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.5.1.1]
b. 22 Jan 1875 [
=>
]
12
Horace Sherman Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.5.1.2]
b. 27 May 1879 [
=>
]
10
Caleb Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.6]
b. 16 Feb 1817 d. 10 May 1892
Maria Howard Emerson
b. 27 Dec 1830 d. 11 Oct 1901
11
Frank Fuller Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.6.1]
b. 18 May 1857 d. 13 Jan 1939
Alice M Gardner
b. Apr 1868
12
Dorothy Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.6.1.1]
b. 27 Nov 1892 d. Jul 1978
12
Edwin Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.6.1.2]
b. 11 Jun 1896 d. Jun 1977
11
Herbert Emerson Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.6.2]
b. 16 Jan 1859 d. 18 Jan 1931
Nancy Sophia Brigham
b. 29 Sep 1862 d. 1 Mar 1943
12
Russell Brigham Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.6.2.1]
b. 7 Sep 1893 d. 20 Feb 1969
12
Phyllis Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.6.2.2]
b. 15 Nov 1895
12
Marjory Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.6.2.3]
b. 1896
11
Eugene Clifford Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.6.3]
b. 24 Nov 1863 d. 13 Sep 1924
+
Elizabeth Howland Hutchinson
b. 7 Dec 1856
11
Carrie Maria Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.6.4]
b. 4 Sep 1865
Edward Augustus Rich
b. 29 Jul 1844 d. Bef 1930
12
Priscilla Augusta Rich
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.6.4.1]
b. 19 Oct 1898 d. 13 Apr 1899
12
Edward Augustus Rich
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.6.4.2]
b. 19 May 1900 d. 2 Nov 1982
10
George Taft Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.7]
b. 18 Mar 1819
Abbie Ann Robinson
b. Abt 1825
11
George Thurston Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.7.1]
b. 4 Jul 1846 d. 30 Jan 1933
Arvilla Richardson Thayer
b. 4 Feb 1850 d. 29 Oct 1902
12
Mabel Florence Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.7.1.1]
b. 13 Dec 1875 d. Aft 1944 [
=>
]
11
Lizzie Green Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.7.2]
b. 2 Sep 1857 d. 3 May 1879
Horace Edward Bigelow
b. 9 Jun 1857
12
Daughter Bigelow
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.7.2.1]
b. 1879
12
Geraldine Murdock Bigelow
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.7.2.2]
b. 16 Apr 1879
12
Gretchen M. Bigelow
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.7.2.3]
b. 1880 [
=>
]
10
Harriet E. Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.8]
b. 6 Feb 1821 d. 30 Nov 1904
David Franum Wood
b. 16 Feb 1818 d. 4 Feb 1896
11
Arthur Eugene Wood
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.8.1]
b. 20 Jan 1844 d. 20 Apr 1920
Clara Hubbard Wood
b. Dec 1848
12
Alice Marion Wood
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.8.1.1]
b. 20 Nov 1872 d. 16 Sep 1897
11
Hattie Esther Wood
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.8.2]
b. 5 Aug 1855
Walter M Farwell
b. 1852 d. 13 Apr 1910
12
Laurence Wood Farwell
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.8.2.1]
b. 14 Sep 1885 d. Jan 1965
10
Chapin Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.9]
b. 20 Jun 1823 d. 17 Sep 1882
Julia A Smith
b. 1824 d. 21 Jun 1909
11
Luther Oscar Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.9.1]
b. 6 Oct 1848 d. 1 Nov 1904
Harriet Flora Huntress
b. 13 Nov 1850 d. 14 Mar 1935
12
Minnie Uranah Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.9.1.1]
b. 8 Aug 1872 d. 22 Sep 1872
12
Oscar Eugene Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.9.1.2]
b. 7 Jul 1876 d. 24 Jan 1912 [
=>
]
12
Walter Ernest Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.9.1.3]
b. 16 Jan 1879 d. 1 Feb 1896
12
Alice Evaline Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.9.1.4]
b. 10 Jul 1881 d. 12 Jun 1923 [
=>
]
12
George Luther Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.9.1.5]
b. 21 Mar 1887
12
Arthur Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.9.1.6]
b. 18 Jul 1889
11
Loren Nelson Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.9.2]
b. 3 Jul 1850 d. 11 May 1923
Eda Annella Robinson
b. 10 Aug 1862 d. 1932
12
Morton I Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.9.2.1]
b. 12 Nov 1889 d. 20 Mar 1933
11
Eldoras Filasker Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.9.3]
b. 18 Jun 1852
Jane Maxwell
b. Dec 1852 d. 3 Nov 1935
12
Minnie Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.9.3.1]
b. 13 Aug 1875 d. 12 Feb 1946 [
=>
]
12
William Henry Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.9.3.2]
b. 29 Oct 1877
11
William Fuller Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.9.4]
b. 19 Jun 1855 d. 26 Nov 1924
Maria Sophia Giles
b. 13 Jul 1857 d. 9 Nov 1940
12
Lilla Gertrude Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.9.4.1]
b. 20 Jun 1883 d. 24 Jan 1951 [
=>
]
12
Ada Emma Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.9.4.2]
b. 29 Nov 1885 d. 2 Jan 1950 [
=>
]
12
Cora May Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.9.4.3]
b. 7 Feb 1889 d. 1959
12
Mamie Giles Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.9.4.4]
b. 6 May 1892 d. 2 Apr 1896
11
Emma E Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.9.5]
b. 30 May 1857 d. 23 Jul 1913
Albertus D Matthewson
b. 29 Nov 1850 d. 19 Mar 1911
12
Frederick E Mathewson
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.9.5.1]
b. 23 Nov 1874
Aaron William Mason
b. 15 Aug 1847 d. 19 Mar 1904
12
William C Mason
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.9.5.2]
b. 14 Jul 1895 d. 16 Jul 1895
10
Mary Ann Murdock
[1.1.4.4.1.2.1.2.7.10]
b. 18 Jun 1825 d. 27 Aug 1834
9
Moses Taft
[1.1.4.4.1.2.1.2.8]
b. 14 Jul 1788 d. 26 Jun 1810
9
Abigail Taft
[1.1.4.4.1.2.1.2.9]
b. 24 Jan 1791 d. 15 May 1837
Chandler Taft
b. 29 May 1792
10
Augustine Calvin Taft
[1.1.4.4.1.2.1.2.9.1]
b. 11 May 1817
Deborah Millett Taylor
11
Alice Bradford Taft
[1.1.4.4.1.2.1.2.9.1.1]
b. 26 Oct 1841
11
Edward A Taft
[1.1.4.4.1.2.1.2.9.1.2]
b. 8 Apr 1845
8
Ruth Taft
[1.1.4.4.1.2.1.3]
b. 19 Feb 1740 d. 27 Jun 1797
8
Moses Taft
[1.1.4.4.1.2.1.4]
b. 21 Dec 1742
8
Margaret Taft
[1.1.4.4.1.2.1.5]
b. 19 Feb 1743 d. 3 Oct 1761
8
Nahum Taft
[1.1.4.4.1.2.1.6]
b. 17 Aug 1745
8
Priscilla Taft
[1.1.4.4.1.2.1.7]
b. 30 Apr 1749 d. 12 Sep 1833
Timothy Taft
b. 3 Apr 1750 d. 30 Nov 1808
9
Marcy Taft
[1.1.4.4.1.2.1.7.1]
b. 28 Sep 1771 d. 1 Aug 1848
+
Ezekiah Preston
b. Abt 1771
9
Josiah Taft
[1.1.4.4.1.2.1.7.2]
b. 3 May 1774
9
Abigail Taft
[1.1.4.4.1.2.1.7.3]
b. 14 Jan 1777 d. 17 Dec 1832
Moses Stone
b. 2 Mar 1775 d. 10 May 1803
10
Jonas Stone
[1.1.4.4.1.2.1.7.3.1]
b. 6 Jun 1795 d. 30 Sep 1795
10
Sukey Stone
[1.1.4.4.1.2.1.7.3.2]
b. 19 Feb 1798
9
Polly Taft
[1.1.4.4.1.2.1.7.4]
b. 1779 d. 5 Sep 1785
9
Timothy Taft
[1.1.4.4.1.2.1.7.5]
b. 1782 d. 5 Jan 1818
Mary "Polly" Reidel
b. 8 Feb 1784 d. 8 Feb 1863
10
Timothy Clark Taft
[1.1.4.4.1.2.1.7.5.1]
b. 21 Jul 1800 d. 11 May 1872
Mary A Hitchcock
b. 4 Jan 1802 d. 26 Oct 1842
11
Samuel Adams Taft
[1.1.4.4.1.2.1.7.5.1.1]
b. 11 Mar 1830 d. 5 Feb 1916
Jennie M Holt
b. 1841 d. 10 Feb 1882
12
Emma Julia Taft
[1.1.4.4.1.2.1.7.5.1.1.1]
b. 19 Jun 1865 d. 15 Jun 1929 [
=>
]
11
Elizabeth C Taft
[1.1.4.4.1.2.1.7.5.1.2]
b. 6 Jun 1834 d. 13 Dec 1915
Franklin E Hall
b. 15 Sep 1829 d. 3 Jun 1907
12
Elizabeth C Hall
[1.1.4.4.1.2.1.7.5.1.2.1]
b. 8 Jan 1855 [
=>
]
12
Frank Erwin Hall
[1.1.4.4.1.2.1.7.5.1.2.2]
b. 6 Dec 1861 d. 26 Dec 1943 [
=>
]
12
Edith Mabel Hall
[1.1.4.4.1.2.1.7.5.1.2.3]
b. 13 Apr 1870 d. 2 Aug 1952 [
=>
]
12
Gertrude Susan Hall
[1.1.4.4.1.2.1.7.5.1.2.4]
b. 26 Apr 1872 d. 6 Dec 1918 [
=>
]
10
Adolphus Taft
[1.1.4.4.1.2.1.7.5.2]
b. Abt 1804
10
Harry Taft
[1.1.4.4.1.2.1.7.5.3]
b. Abt 1806
10
Ezekiel Preston Taft
[1.1.4.4.1.2.1.7.5.4]
b. Abt 1807
10
Washington Taft
[1.1.4.4.1.2.1.7.5.5]
b. Abt 1808 d. Abt 1823
10
Charlotte Clark Taft
[1.1.4.4.1.2.1.7.5.6]
b. Abt 1810
+
Hyman Sage
b. Abt 1810
10
Christine Taft
[1.1.4.4.1.2.1.7.5.7]
b. 1811 d. 8 Jul 1847
+
George Heath
b. Abt 1811
10
Jacob R Taft
[1.1.4.4.1.2.1.7.5.8]
b. 29 Oct 1814 d. 1 Jan 1875
+
Caroline Cowles
b. 10 Jun 1817 d. 25 Jun 1875
9
Joseph Taft
[1.1.4.4.1.2.1.7.6]
b. 1784
9
Jonas Taft
[1.1.4.4.1.2.1.7.7]
b. 1786
9
Polly Taft
[1.1.4.4.1.2.1.7.8]
b. 1788 d. 1859
8
Joseph Taft
[1.1.4.4.1.2.1.8]
b. 6 Jul 1751 d. 2 Jul 1828
Hannah Keith
b. 17 Jul 1753 d. 2 Apr 1842
9
Oliver Taft
[1.1.4.4.1.2.1.8.1]
b. 6 Nov 1771 d. 20 Feb 1853
Chloe
b. 1782 d. 24 Nov 1841
10
Olive Taft
[1.1.4.4.1.2.1.8.1.1]
b. 1 Mar 1806 d. 27 Jan 1867
10
Amariah Taft
[1.1.4.4.1.2.1.8.1.2]
b. 19 Sep 1807 d. 28 Aug 1873
Mary Richards
b. Abt 1819 d. 22 Apr 1875
11
Ophelia Adams Taft
[1.1.4.4.1.2.1.8.1.2.1]
b. 23 Jan 1841
David Ruggles Edgarton
b. 1827
12
Florence Elizabeth Edgarton
[1.1.4.4.1.2.1.8.1.2.1.1]
b. 25 Jan 1867 [
=>
]
12
Mary Lelia Edgarton
[1.1.4.4.1.2.1.8.1.2.1.2]
b. 15 Apr 1868
11
Mary Elizabeth Taft
[1.1.4.4.1.2.1.8.1.2.2]
b. 23 May 1843 d. 8 Apr 1845
11
Francis Amariel Taft
[1.1.4.4.1.2.1.8.1.2.3]
b. 18 Sep 1847 d. 28 Jul 1848
10
Oliver Taft
[1.1.4.4.1.2.1.8.1.3]
b. 16 Jun 1812 d. 25 Mar 1876
Sarah Richardson
b. 1821
11
Horace H Taft
[1.1.4.4.1.2.1.8.1.3.1]
b. 1846 d. 11 May 1863
11
Jennis Isadora Taft
[1.1.4.4.1.2.1.8.1.3.2]
b. 12 Apr 1857 d. 21 Aug 1863
10
Maryan Taft
[1.1.4.4.1.2.1.8.1.4]
b. 9 Jul 1814
Hosea Aldrich
b. 14 Mar 1803
11
Chloe M Aldrich
[1.1.4.4.1.2.1.8.1.4.1]
b. 17 Jan 1838
11
Watee E Aldrich
[1.1.4.4.1.2.1.8.1.4.2]
b. 1 Sep 1840
11
Sylvia Ann Aldrich
[1.1.4.4.1.2.1.8.1.4.3]
b. 20 Jul 1844
10
George Washington Taft
[1.1.4.4.1.2.1.8.1.5]
b. 13 May 1823
Laura Ann M Taft
b. 26 Jun 1824 d. 26 May 1855
10
Laura Ann Maria Taft
[1.1.4.4.1.2.1.8.1.6]
b. 7 Jul 1844
10
Son Taft
[1.1.4.4.1.2.1.8.1.7]
b. 7 Jul 1844 d. 21 Jul 1844
10
Joseph K Taft
[1.1.4.4.1.2.1.8.1.8]
b. 25 Sep 1846 d. Jul 1868
10
Chloe Jane Taft
[1.1.4.4.1.2.1.8.1.9]
b. 25 Nov 1849
9
Huldah Taft
[1.1.4.4.1.2.1.8.2]
b. 17 Feb 1775 d. Bef 21 May 1780
9
Huldah Taft
[1.1.4.4.1.2.1.8.3]
b. 21 May 1780 d. 11 Oct 1811
Parker Tyler
b. 14 Nov 1790 d. 28 Jun 1853
10
Huldah Tyler
[1.1.4.4.1.2.1.8.3.1]
b. 4 Oct 1811
Matthew Borland
b. Abt 1800
11
Huldah J Borland
[1.1.4.4.1.2.1.8.3.1.1]
b. 28 Sep 1831 d. 10 Nov 1907
Henry Nichols
b. 31 Aug 1824
12
Edwin O Nichols
[1.1.4.4.1.2.1.8.3.1.1.1]
b. 3 May 1856 [
=>
]
12
George R Nichols
[1.1.4.4.1.2.1.8.3.1.1.2]
b. 7 Feb 1860 d. 25 Jun 1913
12
Edith Ellen Nichols
[1.1.4.4.1.2.1.8.3.1.1.3]
b. 18 Dec 1866 d. 6 Dec 1948 [
=>
]
11
Margaret Borland
[1.1.4.4.1.2.1.8.3.1.2]
b. 13 Apr 1836 d. 21 Oct 1882
John Vaughn
b. 29 Jan 1833 d. 22 Feb 1905
12
Martha Anna Vaughn
[1.1.4.4.1.2.1.8.3.1.2.1]
b. 20 May 1861 d. 6 Nov 1897
12
Samuel Ellsworth Vaughn
[1.1.4.4.1.2.1.8.3.1.2.2]
b. 31 May 1863 d. 10 Oct 1866
12
Charles Leslie Vaughn
[1.1.4.4.1.2.1.8.3.1.2.3]
b. 6 Jan 1866 d. 26 Apr 1922 [
=>
]
12
Rosalie Vaughn
[1.1.4.4.1.2.1.8.3.1.2.4]
b. 22 Feb 1870 d. 2 Jan 1939
12
Mary Isabelle Vaughn
[1.1.4.4.1.2.1.8.3.1.2.5]
b. 24 Aug 1873 d. 7 May 1952
11
Samuel Borland
[1.1.4.4.1.2.1.8.3.1.3]
b. Abt 1841
11
John P Borland
[1.1.4.4.1.2.1.8.3.1.4]
b. Abt 1849
10
Hannah Tyler
[1.1.4.4.1.2.1.8.3.2]
b. 4 Oct 1811 d. 18 Oct 1811
10
Martha Almira Tyler
[1.1.4.4.1.2.1.8.3.3]
b. 28 Sep 1830 d. 16 Oct 1909
William S Jones
b. 26 Sep 1827 d. 26 Sep 1907
11
Anna Almira Jones
[1.1.4.4.1.2.1.8.3.3.1]
b. 16 Jun 1850 d. 2 May 1922
Thomas Lyon Mix
b. 27 Jul 1848 d. 20 Jun 1936
12
Bessie Mix
[1.1.4.4.1.2.1.8.3.3.1.1]
b. 27 Nov 1873 d. 28 Jun 1888
12
Bertha Ann Mix
[1.1.4.4.1.2.1.8.3.3.1.2]
b. 15 Aug 1875 d. 20 Jul 1955 [
=>
]
12
Alpha William Mix
[1.1.4.4.1.2.1.8.3.3.1.3]
b. 1 Mar 1877 d. 7 Jan 1905
12
Rufus Hayes Mix
[1.1.4.4.1.2.1.8.3.3.1.4]
b. 22 Sep 1878 d. 3 Oct 1970 [
=>
]
12
Effie Sophia Mix
[1.1.4.4.1.2.1.8.3.3.1.5]
b. 24 Aug 1880 d. 9 Jan 1974 [
=>
]
12
Raymond Lyon Mix
[1.1.4.4.1.2.1.8.3.3.1.6]
b. 28 Apr 1882 d. 19 Dec 1973
12
George W Mix
[1.1.4.4.1.2.1.8.3.3.1.7]
b. 22 Jul 1884 d. 1 Jan 1949
12
Benjamin Harrison Mix
[1.1.4.4.1.2.1.8.3.3.1.8]
b. 14 Aug 1887 d. 6 Dec 1964 [
=>
]
12
Dora Mix
[1.1.4.4.1.2.1.8.3.3.1.9]
b. 21 Jul 1891 d. 6 Aug 1891
11
Wilber Jones
[1.1.4.4.1.2.1.8.3.3.2]
b. 1852
11
Albert J Jones
[1.1.4.4.1.2.1.8.3.3.3]
b. 10 Jun 1857 d. 17 Jun 1937
Minnie Bell Smith
b. 1863 d. Aug 1911
12
Zell Marjane Jones
[1.1.4.4.1.2.1.8.3.3.3.1]
b. 14 Jun 1892
12
Doris L Jones
[1.1.4.4.1.2.1.8.3.3.3.2]
b. Mar 1896
+
Hancie P Naylor
b. 10 Jun 1863 d. 23 Sep 1943
11
Eva Jones
[1.1.4.4.1.2.1.8.3.3.4]
b. 29 May 1861 d. 13 Aug 1924
+
William Manning Harned
b. 1857
11
Wilbur Sherman Jones
[1.1.4.4.1.2.1.8.3.3.5]
b. 17 Oct 1865 d. 1942
+
Mary Elizabeth Brown
b. 1863
9
Hannah Taft
[1.1.4.4.1.2.1.8.4]
b. 29 Sep 1783
9
Peter Taft
[1.1.4.4.1.2.1.8.5]
b. 24 Apr 1786
8
Luke Taft
[1.1.4.4.1.2.1.9]
b. 10 Aug 1754
8
Joanna Taft
[1.1.4.4.1.2.1.10]
b. 26 Jun 1756 d. 30 Sep 1761
8
Josiah Taft
[1.1.4.4.1.2.1.11]
b. 1 Oct 1758 d. 29 Sep 1761
7
Elisabeth Thayer
[1.1.4.4.1.2.2]
b. 29 Jan 1719 d. 1725
7
Peter Thayer
[1.1.4.4.1.2.3]
b. 16 Apr 1720 d. Aft 1761
Sarah Holbrook
b. Abt 1719 d. 1800
8
Naomi Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.1]
b. 4 Jul 1751
Stephen Corrary
b. 16 Dec 1746
9
Sarah Crary
[1.1.4.4.1.2.3.1.1]
b. 21 Jul 1769
9
Ruth Crary
[1.1.4.4.1.2.3.1.2]
b. 18 Feb 1771
9
Phoebe Crary
[1.1.4.4.1.2.3.1.3]
b. 21 May 1775
9
Chloe Crary
[1.1.4.4.1.2.3.1.4]
b. 21 Apr 1777
9
Joanna Crary
[1.1.4.4.1.2.3.1.5]
b. 7 Feb 1779
9
Rachel Crary
[1.1.4.4.1.2.3.1.6]
b. 18 Jun 1780
9
Phoebe Crary
[1.1.4.4.1.2.3.1.7]
b. 13 May 1782
9
Stephen Crary
[1.1.4.4.1.2.3.1.8]
b. 1 Jun 1784
9
Sullivan Crary
[1.1.4.4.1.2.3.1.9]
b. 18 Apr 1786
8
Reuben Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.2]
b. 27 Jun 1753 d. 9 Jun 1804
Abigail Wood
b. 30 Aug 1759 d. 22 Jun 1845
9
Chloe Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.2.1]
b. 8 Nov 1781 d. Abt 1870
Archibald Clark
b. Abt 1770 d. 3 Nov 1821
10
Betsey Clark
[1.1.4.4.1.2.3.2.1.1]
b. Abt 1800
10
Sophia Clark
[1.1.4.4.1.2.3.2.1.2]
b. Abt 1802
10
Archibald Clark
[1.1.4.4.1.2.3.2.1.3]
b. Abt 1804
10
Sarah Clark
[1.1.4.4.1.2.3.2.1.4]
b. Abt 1806
10
Abigail Clark
[1.1.4.4.1.2.3.2.1.5]
b. Abt 1808
10
Chloe Clark
[1.1.4.4.1.2.3.2.1.6]
b. Abt 1812
10
Augusta Clark
[1.1.4.4.1.2.3.2.1.7]
b. Abt 1814
10
Josephine Clark
[1.1.4.4.1.2.3.2.1.8]
b. Abt 1816
10
Zephrona Clark
[1.1.4.4.1.2.3.2.1.9]
b. Abt 1818
9
Abigail Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.2.2]
b. 11 Oct 1782
Martin Lewis
b. Abt 1779
10
Archibald Lewis
[1.1.4.4.1.2.3.2.2.1]
b. Abt 1802
10
Alexander Lewis
[1.1.4.4.1.2.3.2.2.2]
b. Abt 1805
10
Louisa Lewis
[1.1.4.4.1.2.3.2.2.3]
b. Abt 1807
10
Emma Lewis
[1.1.4.4.1.2.3.2.2.4]
b. Abt 1809
10
William Lewis
[1.1.4.4.1.2.3.2.2.5]
b. Abt 1811
10
Martin Lewis
[1.1.4.4.1.2.3.2.2.6]
b. Abt 1813
10
Abigail Lewis
[1.1.4.4.1.2.3.2.2.7]
b. Abt 1815
10
Eveline Lewis
[1.1.4.4.1.2.3.2.2.8]
b. Abt 1817
10
David Lewis
[1.1.4.4.1.2.3.2.2.9]
b. Abt 1819
9
Eunice Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.2.3]
b. May 1785 d. Mar 1790
9
Reuben Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.2.4]
b. 6 Oct 1786 d. 8 Nov 1860
Mary Vandervater
b. Abt 1792 d. 2 Oct 1845
10
Abigail Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.2.4.1]
b. 1814
Milton M Morris
b. Abt 1810 d. 1837
11
Caroline Morris
[1.1.4.4.1.2.3.2.4.1.1]
b. 1834
Lorenzo D Harvey
b. Abt 1810
11
Henry Harvey
[1.1.4.4.1.2.3.2.4.1.2]
b. 1 Jul 1843 d. 1861
11
Frances M Harvey
[1.1.4.4.1.2.3.2.4.1.3]
b. 1 Jan 1845
11
Kate Harvey
[1.1.4.4.1.2.3.2.4.1.4]
b. 1847
10
Mary Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.2.4.2]
b. Abt 1817
10
Daniel V Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.2.4.3]
b. 24 Mar 1820 d. 1880
Nancy R Cook
b. 7 Jun 1823 d. 15 Jun 1899
11
George W Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.2.4.3.1]
b. 26 Sep 1845 d. 1855
11
Mary Jane Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.2.4.3.2]
b. 16 Feb 1848 d. 1 Oct 1850
11
Harriet Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.2.4.3.3]
b. 14 Jan 1851
11
Edward Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.2.4.3.4]
b. 17 Nov 1853
11
Carrie Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.2.4.3.5]
b. 7 Aug 1857 d. 11 Sep 1857
11
Frank Cook Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.2.4.3.6]
b. 24 Jun 1862
10
Joshua G Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.2.4.4]
b. 24 Nov 1823 d. 14 Dec 1878
Adelia M Barker
b. 1 Dec 1828
11
Jane Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.2.4.4.1]
b. 17 Jan 1847
11
Charles A Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.2.4.4.2]
b. 1 Nov 1848
11
Abigail L Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.2.4.4.3]
b. 14 Jan 1851
11
William S Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.2.4.4.4]
b. 7 Dec 1852
11
Thomas D Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.2.4.4.5]
b. 29 Aug 1855
11
Mary E Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.2.4.4.6]
b. 1 Nov 1859
10
Joseph C Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.2.4.5]
b. 9 Mar 1827 d. 28 Oct 1886
Lucretia Chambers
b. 22 May 1829 d. Bef Jun 1880
11
Mary E Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.2.4.5.1]
b. 31 Aug 1850 d. 7 Jun 1857
11
John C Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.2.4.5.2]
b. 24 Jul 1852 d. 23 Jul 1861
11
George A Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.2.4.5.3]
b. 14 Nov 1855
11
Susan M Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.2.4.5.4]
b. 28 Jul 1857 d. 8 Feb 1907
11
Benjamin F Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.2.4.5.5]
b. 4 Oct 1864
10
John S Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.2.4.6]
b. 12 Nov 1829
10
Amanda Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.2.4.7]
b. 1833 d. 1836
9
Salley Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.2.5]
b. 9 Feb 1790 d. 1835
+
Nathaniel S White
b. Abt 1789
9
Sylvanus Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.2.6]
b. 1793
9
Eunice Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.2.7]
b. 5 Mar 1797
Staley Nichols Clarke
b. 24 Mar 1794 d. 14 Oct 1860
10
Sarah E Clarke
[1.1.4.4.1.2.3.2.7.1]
b. 9 Aug 1817
10
Fayette Clarke
[1.1.4.4.1.2.3.2.7.2]
b. 17 Aug 1819
10
Mary D Clarke
[1.1.4.4.1.2.3.2.7.3]
b. 7 Dec 1820
10
Archibald Clarke
[1.1.4.4.1.2.3.2.7.4]
b. 20 Mar 1823 d. 13 Mar 1846
10
Dlyden Clarke
[1.1.4.4.1.2.3.2.7.5]
b. 26 May 1825
10
Stacy Nichols Clarke
[1.1.4.4.1.2.3.2.7.6]
b. 21 Aug 1828 d. 20 Feb 1861
10
Abigail W Clarke
[1.1.4.4.1.2.3.2.7.7]
b. 29 Sep 1830
10
Theadora Clarke
[1.1.4.4.1.2.3.2.7.8]
b. 11 Feb 1833
10
Emma M Clarke
[1.1.4.4.1.2.3.2.7.9]
b. 25 Feb 1835
10
William T Clarke
[1.1.4.4.1.2.3.2.7.10]
b. 20 Jul 1837
9
George Washington Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.2.8]
b. 5 Aug 1799 d. 7 Mar 1865
Martha C Clemmons
b. 13 Mar 1803 d. 11 Apr 1851
10
George W Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.2.8.1]
b. 28 Apr 1826
10
Sylvanus Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.2.8.2]
b. 2 Dec 1827
10
Lucinda Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.2.8.3]
b. 23 Apr 1829
10
Abigail Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.2.8.4]
b. 7 Mar 1830 d. 1853
10
Reuben R Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.2.8.5]
b. 27 Mar 1832 d. 17 Aug 1903
10
Mary Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.2.8.6]
b. 9 Jul 1834 d. 17 Apr 1835
10
Theodore Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.2.8.7]
b. 21 Dec 1835 d. 1911
10
Chauncy Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.2.8.8]
b. 1 Sep 1837
10
Mary Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.2.8.9]
b. 30 Mar 1840 d. 11 Apr 1846
10
Frances Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.2.8.10]
b. 5 Jul 1842
10
Elizabeth
[1.1.4.4.1.2.3.2.8.11]
b. 14 Mar 1846 d. 9 Mar 1847
8
Peter Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3]
b. 2 Oct 1755 d. 1820
Abigail Green
b. 4 Oct 1765 d. 1830
9
Betsy Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.1]
b. 14 Jul 1784 d. 7 Aug 1821
William Daniels
b. Abt 1779 d. 3 Sep 1850
10
Mariana M Daniels
[1.1.4.4.1.2.3.3.1.1]
b. 20 Jul 1806
10
Ora S Daniels
[1.1.4.4.1.2.3.3.1.2]
b. 5 Feb 1808
10
Catharine M Daniels
[1.1.4.4.1.2.3.3.1.3]
b. 17 Mar 1810
10
William A Daniels
[1.1.4.4.1.2.3.3.1.4]
b. 2 May 1814
10
John L Daniels
[1.1.4.4.1.2.3.3.1.5]
b. 31 Jan 1816
10
Peter D Daniels
[1.1.4.4.1.2.3.3.1.6]
b. 20 May 1817
10
Marvin N Daniels
[1.1.4.4.1.2.3.3.1.7]
b. 21 Mar 1819
10
Mary E Daniels
[1.1.4.4.1.2.3.3.1.8]
b. 30 Jan 1821
9
Emery Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.2]
b. 27 Jan 1786 d. 19 May 1851
Lydia Mobbs
b. 10 May 1805
10
Martin B Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.1]
b. 13 Dec 1826
+
Laura Burton
b. 1828
10
Ora Sophronia Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.2]
b. 3 Jan 1827 d. 26 Jan 1864
Joseph Ferguson
b. 30 Nov 1819 d. 19 Sep 1893
11
Robert Emory Ferguson
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.2.1]
b. 1848 d. 26 Jan 1864
11
Julie E Farguson
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.2.2]
b. 14 Nov 1849 d. 1 May 1917
11
George Thomas Ferguson
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.2.3]
b. 10 Feb 1854 d. 8 Aug 1916
11
Jane Ferguson
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.2.4]
b. 1856
11
John Jasper Ferguson
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.2.5]
b. 1 Mar 1856 d. 6 Feb 1935
11
Edward Ferguson
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.2.6]
b. 1858
11
Mary Saphronia Ferguson
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.2.7]
b. 1861
11
Joseph Delbert Ferguson
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.2.8]
b. Mar 1863
11
Daughter Ferguson
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.2.9]
b. Mar 1863 d. Mar 1863
10
Asahel William Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.3]
b. 12 Jan 1829 d. Bef 1900
Ellen Ferrell
b. 25 Jun 1831
11
William E Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.3.1]
b. 2 Jul 1854 d. 30 May 1855
11
Mary Ellen Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.3.2]
b. 13 Mar 1856
Edwin J Durfee
b. 5 Aug 1855
12
Estella May Durfee
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.3.2.1]
b. 15 Jan 1876 d. 6 Mar 1963 [
=>
]
12
Walter Chesley Durfee
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.3.2.2]
b. 28 Sep 1879 d. 7 Dec 1884
11
Henry Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.3.3]
b. 22 Feb 1858 d. 3 Apr 1858
11
Addie Catherine Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.3.4]
b. 11 Mar 1859 d. 9 Oct 1859
11
William Lawrence Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.3.5]
b. 1 Oct 1860 d. 18 Jun 1934
Clara Elizabeth Brunk
b. 5 Mar 1861 d. 28 Nov 1951
12
Carrie Belle Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.3.5.1]
b. 21 Dec 1884 d. 19 Mar 1972 [
=>
]
12
Florence Estella Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.3.5.2]
b. 5 Oct 1886 d. 30 Mar 1965
12
Lawrence Michael Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.3.5.3]
b. 11 Feb 1888 d. 30 Jun 1955
11
Fannie A Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.3.6]
b. 25 Jan 1863
11
Michael R Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.3.7]
b. 20 Mar 1865 d. 2 Jul 1867
11
Asa W Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.3.8]
b. 9 Aug 1865 d. 16 Nov 1947
11
John R Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.3.9]
b. 19 Feb 1870 d. 14 Sep 1870
10
Samuel Allen Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.4]
b. 19 Dec 1830 d. Abt 5 Sep 1909
10
William Henry Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.5]
b. 5 Mar 1833 d. 4 Jul 1911
Ladiska Alice Thurston
b. 1838
11
George A Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.5.1]
b. Aug 1859 d. 17 Mar 1923
+
Elizabeth Neal
b. 1870 d. 18 Nov 1940
11
Leo Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.5.2]
b. Abt 1860
11
Frank L Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.5.3]
b. 1861
Jennie Fuzey
b. Jun 1860
12
Nina May Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.5.3.1]
b. Nov 1882
12
Lulu Blanche Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.5.3.2]
b. Jun 1884
12
Rhoda Leona Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.5.3.3]
b. Aug 1885
12
Frank William Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.5.3.4]
b. 5 Sep 1887 d. 17 Sep 1962
12
Robert James Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.5.3.5]
b. Jun 1889
12
Ella Izata Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.5.3.6]
b. Apr 1891
12
Charles Alverton Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.5.3.7]
b. 17 Sep 1892 d. 18 Oct 1961 [
=>
]
11
Charles Ellsworth Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.5.4]
b. Feb 1862
Anna Marie Murphy
b. Sep 1864
12
Alfred William Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.5.4.1]
b. 27 Dec 1892 d. 20 Jun 1956 [
=>
]
12
Florence Marie Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.5.4.2]
b. 18 Jul 1893 d. May 1974
12
Son Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.5.4.3]
b. 1896 d. 1898
12
Ralph Leo Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.5.4.4]
b. 1 Sep 1897 d. 7 Mar 1957
11
Mabel G Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.5.5]
b. Abt 1872
11
Myrtle L Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.5.6]
b. Abt 1877
10
Charles Edwin Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.6]
b. 15 May 1835
Elinor Jane Walden
b. Aug 1845 d. 1919
11
Wilson Wilsey Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.6.1]
b. 27 Jan 1866 d. 24 Jun 1897
11
Lewis William Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.6.2]
b. 3 Oct 1872 d. 3 May 1951
11
Edwin Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.6.3]
b. Abt 1874
10
Anna Valina Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.7]
b. 23 Dec 1838 d. 28 Feb 1902
Hill
b. Abt 1834 d. Abt 1864
11
Daughter Hill
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.7.1]
b. Abt 1861 d. Bef 1870
11
Ada B Hill
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.7.2]
b. 1862 d. Bef 1875
Joseph Ferguson
b. 30 Nov 1819 d. 19 Sep 1893
11
Minnie Mae Ferguson
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.7.3]
b. 1867
11
Samuel Ferguson
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.7.4]
b. 1869
11
James F Ferguson
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.7.5]
b. 1873
11
Hal Ferguson
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.7.6]
b. 1876
10
Harriet Phebe Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.8]
b. 3 Jan 1841 bur. 4 May 1888
Thomas Henry Jones
b. 1835 d. 11 Mar 1892
11
George Henry Jones
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.8.1]
b. Aug 1856 d. 25 Feb 1932
11
Martha Anne Jones
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.8.2]
b. 26 Mar 1857 d. 28 May 1935
Alfred Tewksbury
b. 9 May 1852 d. 16 Oct 1928
12
Minnie Maud Tewksbury
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.8.2.1]
b. 9 Mar 1878 d. Bef 1960
12
Leslie Roy Tewksbury
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.8.2.2]
b. 31 Jan 1888 d. Jan 1976
11
Mary Eva Jones
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.8.3]
b. 5 Mar 1860 d. 8 Nov 1874
11
Amos Peter Jones
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.8.4]
b. 2 Oct 1863 d. 7 Jul 1948
Alice Mae McCartney
b. 14 Dec 1863 d. 8 Aug 1947
12
Charles Frederick Jones
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.8.4.1]
b. 7 Mar 1887 d. 24 Nov 1948
12
Henry Harrison Jones
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.8.4.2]
b. 5 Oct 1888 d. 9 May 1949
12
John Thomas Jones
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.8.4.3]
b. 13 Jul 1890 d. Aft 1963
12
Carrie Eva Jones
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.8.4.4]
b. 16 Nov 1892 d. 30 Aug 1976
12
Mabel Ruth Jones
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.8.4.5]
b. 23 Nov 1894 d. 21 Jul 1945 [
=>
]
12
Blanche Mae Jones
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.8.4.6]
b. 8 May 1897 d. 27 Nov 1976 [
=>
]
12
Nellie Pearl Jones
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.8.4.7]
b. 9 Jan 1900 d. Dec 1954
12
Frank Willie Jones
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.8.4.8]
b. 23 Feb 1902 d. 4 Oct 1945
12
Amos McCartney Jones
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.8.4.9]
b. 23 Jun 1905 d. 30 Jan 1986
12
Alice Elizabeth Jones
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.8.4.10]
b. 16 Jul 1908 d. 15 Sep 1990
11
Ella Maria Jones
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.8.5]
b. Jun 1864 d. 14 May 1936
Charles Freemont Yeoman
b. 26 Jan 1857 d. 19 Sep 1914
12
Bert William Yeoman
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.8.5.1]
b. 12 Jun 1883 d. 29 Sep 1964
12
Cora Sophia Yeoman
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.8.5.2]
b. 24 Oct 1884 d. 30 Sep 1970 [
=>
]
12
Alta Ella Yeoman
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.8.5.3]
b. 16 Jul 1886
12
Eighty Eight Ann Yeoman
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.8.5.4]
b. 4 Mar 1888
12
Golda Iona Yeoman
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.8.5.5]
b. 24 Jul 1896 d. 1947
12
Nina Marie Yeoman
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.8.5.6]
b. 1 Jan 1899
11
Eliza Iona "Lizzie" Jones
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.8.6]
b. 12 Jul 1868 d. 9 Feb 1933
11
Cora Lydia Jones
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.8.7]
b. 8 May 1869 d. 12 Jan 1954
+
John E Thurlby
b. 12 Mar 1866 d. 26 Jan 1939
11
Franklin Harrison Jones
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.8.8]
b. 1 Sep 1873 d. 18 Nov 1934
11
Charles Emory Jones
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.8.9]
b. Feb 1875 d. 8 Jul 1955
10
Peter H Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.9]
b. 26 Jul 1842 d. 20 Feb 1911
Eliza Devine
b. 1842
11
Texa N Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.9.1]
b. Abt 1869
Franklin Samuel Hart
b. 7 Jan 1867 d. 15 Nov 1939
12
Marie L Hart
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.9.1.1]
b. 28 Jun 1893
10
Louisa M Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.10]
b. 26 Dec 1844
10
George Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.11]
b. 1847
10
Son Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.2.12]
b. 16 Jun 1849
9
Samuel Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.3]
b. 30 Apr 1788 d. 1851
Phebe Allen
b. Abt 1790 d. Aug 1851
10
Calvin Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.3.1]
b. Abt 14 Sep 1806
Almena Roe
b. 8 Apr 1805 d. 1842
11
Erwin Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.3.1.1]
b. 15 Feb 1828
11
Phebe Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.3.1.2]
b. 12 Aug 1832
11
William Henry Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.3.1.3]
b. 15 Nov 1834 d. 17 Sep 1913
11
Harriet Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.3.1.4]
b. Abt 1837
11
Sheldon Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.3.1.5]
b. 22 Nov 1838 d. 1896
11
Edward Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.3.1.6]
b. 15 Aug 1840
11
Louisa Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.3.1.7]
b. Abt 1843
Mary Griffin
b. Abt 1820
11
Jennie Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.3.1.8]
b. 31 Jan 1854
10
Linas Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.3.2]
b. 28 Feb 1808 d. 28 Feb 1859
Elizabeth Cross
b. Abt 1812
11
Millie L C Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.3.2.1]
b. 15 Mar 1855 d. 19 Aug 1856
10
Abigail Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.3.3]
b. 19 Sep 1809
Horace Arnold
b. 22 Nov 1806 d. 15 Apr 1869
11
Francis E Arnold
[1.1.4.4.1.2.3.3.3.3.1]
b. 2 Aug 1834
11
Betsey Arnold
[1.1.4.4.1.2.3.3.3.3.2]
b. 16 Oct 1838
11
Nahum W Arnold
[1.1.4.4.1.2.3.3.3.3.3]
b. 18 Jan 1841
11
Harriet P Arnold
[1.1.4.4.1.2.3.3.3.3.4]
b. 29 May 1845
10
Elizabeth Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.3.4]
b. 13 Jan 1811 d. 1 Mar 1850
Datus Bush
b. 6 Jun 1804
11
Perry Franklin Bush
[1.1.4.4.1.2.3.3.3.4.1]
b. 29 Mar 1836
11
Phebe Ann Bush
[1.1.4.4.1.2.3.3.3.4.2]
b. 31 Jan 1838
11
Emily Bush
[1.1.4.4.1.2.3.3.3.4.3]
b. 17 Dec 1839 d. 5 Feb 1841
11
Paine Bush
[1.1.4.4.1.2.3.3.3.4.4]
b. 8 Oct 1841
11
Franklin Bush
[1.1.4.4.1.2.3.3.3.4.5]
b. 18 Sep 1843
11
George F Bush
[1.1.4.4.1.2.3.3.3.4.6]
b. 5 Mar 1846
11
Sarah P Bush
[1.1.4.4.1.2.3.3.3.4.7]
b. 17 Aug 1848 d. 4 Oct 1849
10
Oliver Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.3.5]
b. 3 May 1814
Harriet Thayer
b. 24 Sep 1817 d. 1874
11
Austin Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.3.5.1]
b. 5 Nov 1841
11
Abigail Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.3.5.2]
b. 20 Sep 1843
11
Catharina S Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.3.5.3]
b. 12 Feb 1846
11
Datus Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.3.5.4]
b. 11 Jul 1848
11
George Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.3.5.5]
b. 20 Feb 1850
11
Orrin Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.3.5.6]
b. 26 Oct 1852
11
Margaret Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.3.5.7]
b. 22 Jan 1855
11
Dayton Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.3.5.8]
b. 31 Jul 1857
11
Otis Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.3.5.9]
b. Abt 1863 d. 6 Aug 1938
10
Alonzo Peter Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.3.6]
b. 14 Jan 1816
Laura Alvina Thayer
b. 26 Nov 1827
11
George
[1.1.4.4.1.2.3.3.3.6.1]
b. 28 Sep 1846
11
Lorenzo Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.3.6.2]
b. 28 Jun 1848
11
Emily Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.3.6.3]
b. 24 Aug 1849
11
George Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.3.6.4]
b. 16 Nov 1851
11
Franklin Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.3.6.5]
b. 6 Mar 1852
11
Horace Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.3.6.6]
b. 18 Jan 1855 d. 1 Oct 1857
11
Willie Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.3.6.7]
b. 3 May 1857 d. 18 Oct 1860
9
Hyram Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.4]
b. Abt 1790
Elizabeth Perry
b. Abt 1779 d. 23 Mar 1854
10
Rebecca E Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.4.1]
b. 2 Apr 1830
10
George W Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.4.2]
b. 6 May 1832 d. 8 Oct 1854
10
Caroline C Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.4.3]
b. 2 Nov 1834
10
Nancy M Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.4.4]
b. 2 Apr 1838 d. 20 Sep 1848
9
John H Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.5]
b. 25 May 1791
Susan Mitchell Simmons
b. 6 Jun 1797 d. Jan 1872
10
Lucinda Ann Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.5.1]
b. 2 Nov 1826
Lewis Thayer
b. 6 Nov 1796
11
Lois Ann Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.5.1.1]
b. 5 Jan 1857 d. Abt 1933
9
Henry Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.6]
b. 23 Mar 1793 d. Abt 1825
Mercy Moon
b. Abt 1795
10
George Washington Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.6.1]
b. 27 Feb 1817 d. 29 Aug 1892
10
Robert Moon Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.6.2]
b. 27 Feb 1819 d. 14 Sep 1863
10
Mary Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.6.3]
b. 11 Jul 1821
Elizabeth Hall
b. Abt 1803 d. 8 Dec 1864
10
Henry Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.6.4]
b. 14 Mar 1831
10
Marvin S Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.6.5]
b. 19 Aug 1832
10
Ansley Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.6.6]
b. 1836
9
Peter Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.7]
b. 15 Jul 1795
Sarah McCrary
b. 9 Feb 1799
10
Emery Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.7.1]
b. 18 Dec 1816 d. 27 Oct 1885
Tamer Louise Ransom
b. 31 Oct 1821 d. May 1908
11
James A Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.7.1.1]
b. 27 Nov 1845
11
John Emory Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.7.1.2]
b. 18 Jul 1847 d. 28 Feb 1924
11
Alice C Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.7.1.3]
b. 17 Jun 1851
11
Peter B Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.7.1.4]
b. 7 Jan 1855
11
Erastus R Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.7.1.5]
b. 7 Jun 1858
10
Martin D Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.7.2]
b. 27 Sep 1818
Julia Ann Ames
b. 21 Apr 1824 d. 1893
11
Sarah Jane Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.7.2.1]
b. 2 Jul 1848
11
Arvilla C Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.7.2.2]
b. 6 Jan 1851
11
William D Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.7.2.3]
b. 6 Nov 1857
11
Ada Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.7.2.4]
b. 30 Aug 1862
10
Granderson F Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.7.3]
b. 17 Oct 1820
Mary E Fitch
b. 2 Feb 1831
11
Frank Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.7.3.1]
b. 29 Oct 1857
11
Herbert G Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.7.3.2]
b. 12 Mar 1860
10
Cyrena Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.7.4]
b. 27 Feb 1825
Edward Pierce
b. Abt 1821
11
Elliott M Pierce
[1.1.4.4.1.2.3.3.7.4.1]
b. 8 Feb 1846
11
Helen Irene Pierce
[1.1.4.4.1.2.3.3.7.4.2]
b. 25 Jul 1850
10
Lucretia E Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.7.5]
b. 19 Dec 1827
10
Squire M Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.7.6]
b. 3 May 1830
10
James A Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.7.7]
b. 26 Mar 1832
+
Josephine Eliza Hunger
b. 8 Mar 1833
9
Oliver Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.8]
b. 21 Oct 1796
9
Abigail Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.9]
b. 9 Jul 1803
9
Sylvanus Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.10]
b. 9 Aug 1806
Maria Handy Thayer
10
Emily Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.10.1]
b. 2 Sep 1830
10
Erastus Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.10.2]
b. 31 Oct 1831
10
Eliza A Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.3.10.3]
b. 20 Mar 1833
8
Oliver Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.4]
b. 9 Jul 1758
8
Silvanus Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.5]
b. 4 Sep 1762
+
Diana Taft
b. 4 Sep 1767 d. 1830
8
Hannah Thayer
[1.1.4.4.1.2.3.6]
b. 8 Jul 1764
+
Joseph Crossman
b. Abt 1758
7
Thomas Thayer
[1.1.4.4.1.2.4]
b. 23 Jan 1721 d. 26 Jul 1770
7
Temperance Thayer
[1.1.4.4.1.2.5]
b. 3 Jan 1729 d. 24 Feb 1812
7
Oliver Thayer
[1.1.4.4.1.2.6]
b. 13 Mar 1730 d. Bef 1759
7
Joseph Thayer
[1.1.4.4.1.2.7]
b. 10 Mar 1734
7
Elizabeth Thayer
[1.1.4.4.1.2.8]
b. 13 Feb 1724 d. 27 Aug 1797
Captain Joseph Taft
b. 19 Apr 1722 d. 25 Dec 1787
8
Rueben Taft
[1.1.4.4.1.2.8.1]
b. 21 Oct 1742 d. Aft 1761
Faithful Thayer
b. 18 Jun 1744 d. 1827
9
Susannah Taft
[1.1.4.4.1.2.8.1.1]
b. 27 Dec 1761 d. 14 Nov 1825
Isaac Dresser
b. 22 Feb 1759 d. 4 Dec 1835
10
Reuben Dresser
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.1]
b. 11 Jun 1781 d. 5 Sep 1782
10
Betsey Dresser
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.2]
b. 22 May 1783
10
Polly Dresser
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.3]
b. 14 Jun 1785
10
Leonard Dresser
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.4]
b. 7 Aug 1787 d. 26 Apr 1838
Mary Thombs
b. 25 Dec 1790 d. 27 Aug 1866
11
Clarissa Codelia Dresser
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.4.1]
b. 8 Nov 1812
11
Joseph Western Dresser
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.4.2]
b. 7 Jun 1814
11
Leonard Augustus Dresser
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.4.3]
b. 1 Dec 1815 d. 27 Jun 1875
Nancy Garter
b. 27 Jun 1817 d. Nov 1888
12
Mary Dresser
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.4.3.1]
b. 1844
12
Julene Dresser
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.4.3.2]
b. 1854
12
Frank Clifton Dresser
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.4.3.3]
b. 15 Feb 1859 d. 24 May 1907 [
=>
]
12
Orinda Dresser
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.4.3.4]
b. Abt 1861
11
Mary Diana Dresser
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.4.4]
b. 6 Dec 1817 d. 30 Nov 1833
11
Sarah Diana Dresser
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.4.5]
b. 21 Mar 1819
Stephen Cleveland Johnston
b. 17 Sep 1807
12
Martha Johnston
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.4.5.1]
b. Abt 1835
11
Emily Dresser
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.4.6]
b. 25 Dec 1821 d. 25 Dec 1900
John Jackson
b. 19 Jul 1821 d. 14 Feb 1893
12
Isadora Melina Jackson
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.4.6.1]
b. 1844 d. 1913
12
Daniel Jackson
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.4.6.2]
b. 1845 d. Bef 1865
12
Dewitt C Jackson
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.4.6.3]
b. 1846 d. 7 Jul 1914 [
=>
]
12
George Adolph Jackson
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.4.6.4]
b. 1853 d. 11 Dec 1929
12
Charles Montague Jackson
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.4.6.5]
b. 16 Jan 1859 d. 18 Apr 1936
11
James Volna Dresser
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.4.7]
b. 2 Mar 1823 d. 18 Jun 1826
11
Electa Dresser
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.4.8]
b. 18 Aug 1825
+
Peter Cordon
b. Abt 1882
11
Eliza Jane Dresser
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.4.9]
b. 30 Apr 1827
Chamberline
b. Abt 1824
12
George Chamberline
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.4.9.1]
b. Abt 1847
11
Louisa Dresser
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.4.10]
b. 27 Oct 1830 d. 8 Dec 1907
Horatio Nelson Garter
b. 1825
12
Porter Garter
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.4.10.1]
b. Mar 1853 d. 1905 [
=>
]
12
George Garter
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.4.10.2]
b. Dec 1860 [
=>
]
12
Anna B Garter
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.4.10.3]
b. Abt 1863
12
Nelson H Garter
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.4.10.4]
b. Abt 1871
11
John Quincy Dresser
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.4.11]
b. 20 Sep 1832 d. 16 Apr 1918
Frances Gertrude Martin
b. 30 Aug 1856 d. 31 Oct 1952
12
John Qunicy Dresser
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.4.11.1]
b. 19 Oct 1886 d. 4 Sep 1973
10
Clarissa Dresser
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.5]
b. 4 Sep 1789 d. 5 Aug 1867
Roderick Random Stewart
b. 25 Feb 1787 d. 12 Jul 1860
11
Isaac Newton Stewart
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.5.1]
b. 12 Oct 1814 d. 23 Apr 1883
11
Narcissa Random Stewart
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.5.2]
b. 25 Feb 1816 d. 17 Mar 1850
11
Elisha Milton Stewart
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.5.3]
b. 28 Jun 1818 d. 3 Jul 1899
Clarissa Fidelia Cone
b. Abt 1831 d. 1905
12
James W Stewart
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.5.3.1]
b. 4 Jul 1849 d. 1901 [
=>
]
12
Clara Eliza Stewart
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.5.3.2]
b. Sep 1853 [
=>
]
12
Harriet A Stewart
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.5.3.3]
b. May 1857 d. 1 Jan 1858
12
Charles David Stewart
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.5.3.4]
b. 19 Dec 1864 d. 29 Apr 1945 [
=>
]
12
Jennie Frances Stewart
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.5.3.5]
b. 10 Aug 1866 d. 30 Sep 1964 [
=>
]
11
Susannah Dresser Stewart
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.5.4]
b. 28 Jan 1820 d. 8 Jun 1889
James McCartney Allan
b. 1814 d. 1885
12
Mary Amelia Allan
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.5.4.1]
b. 17 Jul 1842 d. 19 Feb 1919 [
=>
]
12
Clara Allan
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.5.4.2]
b. 15 Mar 1845 d. 17 Sep 1917
12
Anna Louise Allan
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.5.4.3]
b. 30 Dec 1851 d. 21 Dec 1933 [
=>
]
11
Permelia Taft Stewart
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.5.5]
b. 7 Jun 1822 d. 4 Dec 1897
Stephen Tyler Hume
b. 3 May 1818 d. 21 May 1908
12
Anne Hume
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.5.5.1]
b. 22 Jun 1847 d. 4 Sep 1847
12
Hume
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.5.5.2]
b. 7 Aug 1848 d. 7 Aug 1848
12
George Hume
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.5.5.3]
b. 17 Jun 1850 d. 27 Jun 1850
12
Ella Narcissa Hume
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.5.5.4]
b. 13 Aug 1851 d. 26 Feb 1933
12
Clara Sarah Hume
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.5.5.5]
b. 31 Dec 1854 d. 21 Jul 1855
12
Stewart Stephen Hume
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.5.5.6]
b. 2 Oct 1859 d. 18 Jul 1860
11
La Fayette Stewart
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.5.6]
b. 21 Jun 1824 d. 17 Jun 1898
Amand Faxon
b. 6 Oct 1826
12
Eugene Fayette Stewart
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.5.6.1]
b. 14 Oct 1850 d. 12 Oct 1871
12
Marion Eolie Stewart
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.5.6.2]
b. 29 Jun 1852
12
Mary Narcissa Stewart
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.5.6.3]
b. 12 Aug 1854 d. 4 Sep 1855
12
Isabel Roxanna Stewart
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.5.6.4]
b. 2 Sep 1857
12
George Faxon Stewart
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.5.6.5]
b. 20 Apr 1862
11
Josiah Taft Stewart
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.5.7]
b. 6 Oct 1828 d. 1 Jan 1855
11
George Washington Stewart
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.5.8]
b. 27 Jan 1830 d. 20 Feb 1902
Sarah Fiester
b. 3 May 1850
12
Erastus Josiah Stewart
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.5.8.1]
b. 4 Jan 1855
12
Alice Permelia Stewart
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.5.8.2]
b. 13 Apr 1857 d. 10 Jul 1906 [
=>
]
Isadore Cornelia Fenner
b. 13 Mar 1848 d. 23 Apr 1924
12
Ida Stewart
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.5.8.3]
b. 22 Oct 1870 d. 22 Oct 1870
12
Mary May Stewart
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.5.8.4]
b. 9 Feb 1872
12
Nellie Lolita Stewart
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.5.8.5]
b. 11 May 1875
12
Albert E Stewart
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.5.8.6]
b. 3 Mar 1878
12
Minnie Isadora Stewart
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.5.8.7]
b. 1885
12
Florence Ethel Stewart
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.5.8.8]
b. 6 Jan 1888
10
Susanna Dresser
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.6]
b. 3 Nov 1791
+
Jonathan Gould
b. Abt 1788
10
Isaac Dresser
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.7]
b. 19 May 1793 d. 5 Feb 1862
Laura Frary
b. 2 Nov 1802 d. Aug 1858
11
James Munroe Dresser
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.7.1]
b. 6 Dec 1820 d. 13 Nov 1833
11
Justus Frary Dresser
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.7.2]
b. 21 Nov 1822 d. 1824
11
Justus Frary Dresser
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.7.3]
b. 7 Nov 1825 d. 1 Jan 1881
Catherine Hughes McAllister
b. 25 Apr 1829 d. 28 Mar 1850
12
Catherine Hughes Dresser
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.7.3.1]
b. 19 Mar 1850 d. 20 Feb 1851
Jane Patterson
b. 5 Apr 1830 d. 24 Apr 1859
12
James Munro Dresser
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.7.3.2]
b. 7 Jun 1854 d. 6 Jan 1879
12
Jessie Lillian Dresser
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.7.3.3]
b. 20 Feb 1856 d. 15 Mar 1878
12
Justus William Dresser
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.7.3.4]
b. 18 Aug 1857 d. 2 Oct 1933 [
=>
]
Annah Livinia Hume
b. 8 Feb 1829 d. 1 Jan 1896
12
Richard Leonard "Dick" Dresser
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.7.3.5]
b. 8 Jul 1862 d. 5 Jun 1945 [
=>
]
12
Laura Kate Dresser
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.7.3.6]
b. 19 Oct 1864 d. 24 Jul 1919
12
Annabel Dresser
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.7.3.7]
b. 20 Feb 1870 d. 29 Sep 1870
11
Theda Dresser
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.7.4]
b. 9 Sep 1827 d. 31 Oct 1895
+
P H Sniff
b. Abt 1825
11
Clarissa Susannah Dresser
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.7.5]
b. 30 Nov 1832 d. 20 Jan 1852
11
Eliza Rebecca Dresser
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.7.6]
b. 7 Feb 1841 d. 9 Sep 1843
+
Emily Marcy
b. Abt 1805
10
Diana Dresser
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.8]
b. 17 Dec 1795
10
David Dresser
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.9]
b. 12 Sep 1797
Dorcas Williams
b. 18 Apr 1794
11
Gilbert W Dresser
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.9.1]
b. Abt 1819 d. 17 Jul 1856
Ann M Dresser
b. 1822
12
Hellen M Dresser
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.9.1.1]
b. 1842
12
Gilbert W Dresser
[1.1.4.4.1.2.8.1.1.9.1.2]
b. 1845
9
Nancy Taft
[1.1.4.4.1.2.8.1.2]
b. 9 Jul 1763 d. 1835
9
Rhoxanna Taft
[1.1.4.4.1.2.8.1.3]
b. 14 Aug 1765 d. 1837
+
Josiah Wood
9
Diana Taft
[1.1.4.4.1.2.8.1.4]
b. 4 Sep 1767 d. 1830
+
Silvanus Thayer
b. 4 Sep 1762
9
Joseph Taft
[1.1.4.4.1.2.8.1.5]
b. 26 Jun 1769
9
Marcy Taft
[1.1.4.4.1.2.8.1.6]
b. 11 Aug 1771 d. 1840
9
Polly Taft
[1.1.4.4.1.2.8.1.7]
b. 9 Jun 1773 d. 26 Oct 1848
Jesse Hurlbut
b. 21 Jul 1769 d. 11 Jan 1848
10
Polly Hurlbut
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.1]
b. 27 Apr 1793 d. 17 Sep 1861
John William Wilcox
b. 8 Jun 1793 d. 17 Sep 1861
11
Stephen Dorman Wilcox
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.1.1]
b. Abt 1815 d. 22 Jan 1863
Nancy Jane Miller
b. 10 Jul 1811 d. 7 Apr 1905
12
Laura Wilcox
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.1.1.1]
b. 23 Dec 1830 d. Bef 1905
12
Poly Wilcox
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.1.1.2]
b. 2 Dec 1832 d. Bef 1905
12
Hariat Wilcox
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.1.1.3]
b. 2 Aug 1835 d. Bef 1905
12
Nathan C Wilcox
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.1.1.4]
b. 31 Dec 1838 d. Bef 1905 [
=>
]
12
Alma Wilcox
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.1.1.5]
b. 28 Nov 1841 d. Bef 1905
12
James King Wilcox
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.1.1.6]
b. 25 Feb 1843 d. 15 Jun 1918 [
=>
]
12
Stephen Franklin Wilcox
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.1.1.7]
b. 21 Oct 1845 d. 25 Oct 1864
12
Eleanor Jane Wilcox
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.1.1.8]
b. 26 Feb 1848 d. 23 Jun 1934 [
=>
]
12
Clarisa Marinza Wilcox
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.1.1.9]
b. 12 Apr 1855 d. 14 Apr 1925 [
=>
]
12
William T Wilcox
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.1.1.10]
b. 24 Jul 1850 d. Bef 1905
12
Nancy R Wilcox
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.1.1.11]
b. 24 Jul 1850 d. Bef 1905
12
George W Wilcox
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.1.1.12]
b. 27 Sep 1852 d. Bef 1905
12
Boy Wilcox
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.1.1.13]
b. Abt 1857
12
Margaret Wilcox
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.1.1.14]
b. 25 Jun 1859
12
Boy Wilcox
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.1.1.15]
b. Abt 1861
11
Roxana Wilcox
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.1.2]
b. Abt 1817 d. 1820
11
Montreville Russell Wilcox
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.1.3]
b. 4 Sep 1826 d. 13 Jan 1888
Susan Minerva Greenfield
b. 2 Apr 1836 d. 27 Dec 1917
12
Eva Wilcox
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.1.3.1]
b. 1858
12
John Wilcox
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.1.3.2]
b. 1860 d. 1917
12
Mary Amy Wilcox
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.1.3.3]
b. 14 Jan 1861 d. 24 Mar 1940 [
=>
]
12
Burgess Greenfield Wilcox
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.1.3.4]
b. Abt 1863 d. 3 Apr 1938 [
=>
]
12
Ovando Wilcox
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.1.3.5]
b. 1870
12
Louisa Wilcox
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.1.3.6]
b. 9 Apr 1877 d. 21 Jun 1955 [
=>
]
10
Reuben Hurlbut
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.2]
b. 7 Apr 1794 d. 28 May 1879
Hannah Moore
b. 1794 d. 18 Nov 1861
11
Diana S Hurlbut
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.2.1]
b. 12 Nov 1816
+
William Dake
11
Polly A Hurlbut
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.2.2]
b. 27 Nov 1818
+
E Dake
11
Sarah Ann Hurlburt
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.2.3]
b. 26 Jul 1820 d. 23 Apr 1908
John Wines
b. 16 Jun 1814 d. 1898
12
Sophia Misplea Wines
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.2.3.1]
b. 19 May 1847 d. 8 Nov 1848
12
Kate Alvira Wines
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.2.3.2]
b. 20 Aug 1848 d. 28 Feb 1932 [
=>
]
12
Frank Pierce Wines
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.2.3.3]
b. 6 Mar 1853 d. 16 Dec 1855
12
Frederick Barlow Wines
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.2.3.4]
b. 24 Oct 1857
11
Chauncey Hurlbut
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.2.4]
b. 7 Nov 1822
11
Marmary Annette Hurlbut
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.2.5]
b. 12 Sep 1824 d. 14 May 1914
+
J Towsley
11
Edwin Taft Monroe Hurlbut
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.2.6]
b. 20 Jun 1828
Helen Coburn
b. 18 Nov 1830
12
Clarence Romeyn Hurlbut
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.2.6.1]
b. 20 Oct 1852
12
Clara Adele Hurlbut
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.2.6.2]
b. 7 Jun 1857
11
Iantha C Hurlbut
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.2.7]
b. 31 May 1826
11
Seth Hurlbut
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.2.8]
b. 12 Jul 1833
+
Margaret Green
b. Abt 1840
11
Sylvia Hurlbut
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.2.9]
b. 7 Feb 1836
10
Aseneth Hurlbut
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3]
b. 7 Jan 1797 d. 26 May 1875
Bechias Dustin
b. 5 Oct 1793 d. 6 Nov 1874
11
David Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.1]
b. 15 Feb 1817 d. 25 Jun 1893
Mary Ann Call
b. 10 Apr 1819 d. 5 Mar 1910
12
Mary Winnifred Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.1.1]
b. 1842 [
=>
]
12
David W Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.1.2]
b. 1845 d. 2 Aug 1849
12
Ida Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.1.3]
b. Sep 1852 [
=>
]
12
Helen J. Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.1.4]
b. Abt 1858
Mary Ann Evans
b. 1818
12
Dorothy Jane Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.1.5]
b. 23 May 1845 d. 19 Feb 1903 [
=>
]
12
Ann Viola Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.1.6]
11
Fornatus Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.2]
b. 17 Feb 1820 d. 11 Oct 1872
Sonora Rosaline Call
b. 29 Dec 1826 d. 5 Mar 1906
12
Andrew Fornatus Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.2.1]
b. 23 Apr 1847 d. 6 May 1910 [
=>
]
12
Oscar Cyril Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.2.2]
b. 5 May 1849 d. 13 Mar 1908 [
=>
]
12
Charles Roscoe Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.2.3]
b. 12 Apr 1851 d. 21 Sep 1927 [
=>
]
12
Elnora Rosaline Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.2.4]
b. 16 Aug 1853 d. 22 Jun 1913 [
=>
]
12
Calista Evaline Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.2.5]
b. 14 Feb 1855 d. 25 Nov 1927 [
=>
]
12
Delbert Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.2.6]
b. 21 Dec 1857 d. 1 Oct 1864
12
Sarah Aseneth Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.2.7]
b. 7 Aug 1859 d. 9 Sep 1860
12
Arthur Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.2.8]
b. 2 Sep 1861 d. 4 Apr 1923 [
=>
]
12
Lillie Ellen Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.2.9]
b. 31 Mar 1864 d. 7 Jul 1884 [
=>
]
12
May Rosetta Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.2.10]
b. 9 Oct 1866 d. 14 May 1922 [
=>
]
12
Fannie Samantha Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.2.11]
b. 15 Apr 1869 d. 13 Mar 1923 [
=>
]
11
Bechias Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.3]
b. 21 Oct 1823 d. Aft 1870
11
Seth Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.4]
b. 21 Oct 1825 d. 2 Dec 1903
Hannah Loveland
b. 28 May 1825 d. 1867
12
Edwin Seth Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.4.1]
b. 28 May 1847 d. 20 Sep 1915
12
Hannah Sophia Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.4.2]
b. 22 Feb 1849 d. 2 Apr 1904
12
William Henry Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.4.3]
b. 28 Jun 1851 d. 1 Nov 1932
12
Chauncey Bechias Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.4.4]
b. 18 Feb 1853 d. 10 Mar 1937
12
Bechies Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.4.5]
b. 18 Feb 1853
12
Chester Moroni Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.4.6]
b. 10 Mar 1854 d. 10 Jan 1910
12
Hyrum Nephi Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.4.7]
b. 27 Oct 1855 d. 31 Jul 1931
12
James Bechias Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.4.8]
b. 24 Dec 1857 d. 6 Sep 1858
12
Nancy Maria Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.4.9]
b. 25 Nov 1859 d. 27 Nov 1859
12
Chauncey Loveland Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.4.10]
b. 27 Nov 1863 d. 4 Mar 1937
12
Levi Jerome Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.4.11]
b. 1 Apr 1865 d. 12 Apr 1930
Ann Reed Everington
b. 18 Dec 1826 d. 11 Jan 1910
12
Byrnina Ann Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.4.12]
b. 17 Jul 1872 d. 23 Sep 1951 [
=>
]
11
Joseph Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.5]
b. 15 Dec 1827 d. 10 Dec 1914
Sarah Phelps Littlefield
b. 12 Jan 1830 d. 21 Sep 1917
12
Hiram Joseph Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.5.1]
b. 11 Jan 1847 d. 3 Mar 1922 [
=>
]
12
Lavina Jane Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.5.2]
b. 31 Jul 1848 d. Abt 1918 [
=>
]
12
Asenath Cecelia Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.5.3]
b. 25 Feb 1850 d. 11 Dec 1943 [
=>
]
12
Izora Eblin Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.5.4]
b. 5 Nov 1859 d. 6 Mar 1948 [
=>
]
Mary Catherine Bickmore
b. 6 Jan 1862 d. 14 Jun 1936
12
Henry Harry Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.5.5]
b. 11 Mar 1879 d. Bef Jun 1880
12
Elizabeth Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.5.6]
b. 7 Apr 1882 d. 11 Nov 1923
12
Tina Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.5.7]
b. 28 Jan 1885 d. 21 Jun 1979
12
Truman Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.5.8]
b. 25 Nov 1885 d. 28 Oct 1886
12
Edward Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.5.9]
b. 22 Oct 1886 d. Abt Oct 1886
12
Evelyn Kathleen Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.5.10]
b. 4 Nov 1887 d. 19 May 1987 [
=>
]
12
Christopher Columbus Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.5.11]
b. 7 Jan 1889 d. 11 Jan 1962 [
=>
]
12
Benjamen Harrison Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.5.12]
b. 5 Apr 1892 d. 22 Dec 1942 [
=>
]
12
Lillie Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.5.13]
b. 5 Apr 1894 d. 27 Jan 1955 [
=>
]
12
Albert McKinley Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.5.14]
b. 9 Aug 1896 d. 6 Dec 1972 [
=>
]
12
Daisey Belle Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.5.15]
b. 9 Sep 1898 d. 12 Nov 1973 [
=>
]
11
Aseneth Cecilia Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.6]
b. 25 Feb 1829 d. Mar 1899
Isaac Allen
b. 22 Apr 1831 d. 12 Jan 1912
12
Sarah E Allen
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.6.1]
b. 26 Mar 1854 d. Bef 1912
12
Isaac Alexander Allen
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.6.2]
b. 26 Mar 1854 d. 8 Nov 1934 [
=>
]
12
James Scott Allen
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.6.3]
b. 1856 d. 15 Nov 1920
12
George Allen
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.6.4]
b. 28 Oct 1857 d. 21 Jan 1875
12
Eliza Amberzine Allen
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.6.5]
b. Abt 1860 d. 19 Aug 1943 [
=>
]
12
Emma Bell Allen
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.6.6]
b. 3 Feb 1860 d. 28 Mar 1943 [
=>
]
12
Truman W Allen
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.6.7]
b. 21 Feb 1862 d. 21 Sep 1882
12
Alice Augusta Allen
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.6.8]
b. 29 Jul 1864 d. 26 Jan 1890 [
=>
]
11
Roxanna Mahalia Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.7]
b. 3 Jul 1833 d. 11 Mar 1903
John Eller Welker
b. 16 Mar 1826 d. 1 Jun 1913
12
Roxana Louisa Welker
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.7.1]
b. 20 Aug 1851 d. 26 Jan 1918 [
=>
]
12
John Eller Welker
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.7.2]
b. 12 Jul 1853 d. 29 Nov 1918 [
=>
]
11
Franklin Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.8]
b. 1834 d. Aft 1885
11
Christopher Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.9]
b. 1837 d. 12 Aug 1898
11
Andrew Dustin
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.3.10]
d. Bef 1845
10
Diana Hurlbut
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.4]
b. 29 Mar 1798 d. 1 Mar 1841
+
George Fox
b. 1794
10
Alma Hurlbut
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.5]
b. 13 Feb 1800
+
Reed
b. Abt 1796
10
Hiram Higgins Hurlbut
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.6]
b. 29 Nov 1801 d. 20 Jul 1864
Lydia McIntyre
b. 18 Aug 1805
11
Mary Hurlbut
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.6.1]
b. 27 Jun 1826 d. 7 Jul 1865
+
Hiram Berry
11
Sarah Hurlbut
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.6.2]
b. 2 Sep 1827
+
Nicholas Youngs
11
Esther Mahala Hurlburt
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.6.3]
b. 20 Jan 1829
+
Samuel F Seeley
b. 1817
11
Jesse Hurlbut
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.6.4]
b. 13 Nov 1830 d. 25 Jul 1874
Mary Jane Richardson
b. 16 May 1841 d. 16 Oct 1909
12
Elizabeth Ester Hurlbut
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.6.4.1]
b. 7 Aug 1866 d. 4 Mar 1885
12
Emma Frances Hurlbut
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.6.4.2]
b. 1 Jul 1868 d. 21 May 1926
12
Jesse David Hurlbut
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.6.4.3]
b. 1 Jul 1871 d. 9 Nov 1962 [
=>
]
11
Matilda Hurlbut
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.6.5]
b. 7 Jun 1832
+
Taylor
11
Urilla Hurlbut
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.6.6]
b. 20 Mar 1834
11
Stephen Hulbert
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.6.7]
b. 28 Dec 1836 d. 1882
Mary Knapp
b. Abt 1840 d. 1873
12
Fred Hulbert
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.6.7.1]
b. Abt 1864
12
Hiram Frank Hulbert
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.6.7.2]
b. 1867
12
Henry Ovando Hulbert
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.6.7.3]
b. 12 Jan 1871 d. 14 Nov 1954 [
=>
]
11
Lydia Hurlbut
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.6.8]
b. 5 May 1838
11
Hiram Hurlbut
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.6.9]
b. 6 Aug 1840
11
John William Hurlbut
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.6.10]
b. 28 Feb 1843
Miranda Chase
b. Abt 1847
12
John Hurlbut
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.6.10.1]
b. 3 Mar 1873 d. 4 Feb 1926
10
Horatio Hurlbut
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.7]
b. 9 Nov 1806 d. 1890
Sabrina Lumbard
b. 1 Sep 1812
11
Vincent Lumbard Hurlbut
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.7.1]
b. 28 Jan 1829
10
Quartus Ovando Hurlbut
[1.1.4.4.1.2.8.1.7.8]
b. 7 Feb 1804 d. 10 Jan 1879
+
Hetty Dann
b. Abt 1808
9
Ruth Taft
[1.1.4.4.1.2.8.1.8]
b. 5 Jul 1778 d. 1860
William Smith
b. Abt 1779
10
Thomas Smith
[1.1.4.4.1.2.8.1.8.1]
b. Abt 1803 d. 21 Feb 1884
9
Betsy Taft
[1.1.4.4.1.2.8.1.9]
b. 24 Mar 1776 d. Feb 1853
Moses Chapin
b. 24 May 1776 d. 19 Jul 1844
10
Joseph Chapin
[1.1.4.4.1.2.8.1.9.1]
b. 15 Jul 1797 d. 12 Jun 1857
Louisa Veaux
b. Abt 1801
11
Sarah Chapin
[1.1.4.4.1.2.8.1.9.1.1]
b. 3 Dec 1825
+
Rufus Ellis Tower
b. 26 Feb 1830
11
Caroline Chapin
[1.1.4.4.1.2.8.1.9.1.2]
c. 14 Aug 1828 d. 20 Aug 1843
Harriet Elizabeth Voax
b. 18 Jul 1821 d. 23 Sep 1872
11
Joseph Chapin
[1.1.4.4.1.2.8.1.9.1.3]
b. 6 May 1845 d. 22 Aug 1846
11
Harriet Louise Chapin
[1.1.4.4.1.2.8.1.9.1.4]
b. 9 Mar 1848
11
Ann Elizabeth Chapin
[1.1.4.4.1.2.8.1.9.1.5]
b. 10 Feb 1851 d. 22 Jun 1853
10
Stephen Chapin
[1.1.4.4.1.2.8.1.9.2]
b. 4 Jan 1801 d. 9 Mar 1843
Julia Emily Taft
b. 1807
11
Moses Williams Chapin
[1.1.4.4.1.2.8.1.9.2.1]
b. 10 Jun 1829 d. 7 May 1884
Catharine Lackey
b. May 1830 d. 26 Feb 1918
12
Lucian Augustine Chapin
[1.1.4.4.1.2.8.1.9.2.1.1]
b. 1 Jul 1850 d. 5 Feb 1904 [
=>
]
12
Alice Augusta Chapin
[1.1.4.4.1.2.8.1.9.2.1.2]
b. 12 Aug 1853
12
Henry Burlingame Chapin
[1.1.4.4.1.2.8.1.9.2.1.3]
b. 3 Jun 1856 d. 23 Aug 1856
12
Julia Emily Chapin
[1.1.4.4.1.2.8.1.9.2.1.4]
b. 30 Aug 1857
10
Ruth Adaline Chapin
[1.1.4.4.1.2.8.1.9.3]
b. 24 Oct 1802 d. 1862
William Thornton
b. Abt 1798 d. 1862
11
Sylvia Taft Thornton
[1.1.4.4.1.2.8.1.9.3.1]
b. 2 Jan 1833
11
William Handy Thornton
[1.1.4.4.1.2.8.1.9.3.2]
b. 16 Jan 1837
11
John Green Thornton
[1.1.4.4.1.2.8.1.9.3.3]
b. 11 Mar 1841
10
Orris Taft Chapin
[1.1.4.4.1.2.8.1.9.4]
b. 27 Jan 1805 d. 20 Dec 1849
Martha Dickson
b. 9 Jan 1804 d. 16 Mar 1856
11
Thomas Rundle Chapin
[1.1.4.4.1.2.8.1.9.4.1]
b. 11 Oct 1829 d. 24 Feb 1905
Elizabeth Shields
b. 6 May 1865
12
Abby Chapin
[1.1.4.4.1.2.8.1.9.4.1.1]
b. 30 May 1899 d. 13 Jul 1899
11
Augustine Francis Chapin
[1.1.4.4.1.2.8.1.9.4.2]
b. 9 Jan 1832 d. 6 Jul 1868
Louisa Roland
b. 27 Mar 1839
12
Thomas Green Chapin
[1.1.4.4.1.2.8.1.9.4.2.1]
b. 22 Feb 1856
12
Rodolph Chapin
[1.1.4.4.1.2.8.1.9.4.2.2]
b. 2 Sep 1858
12
Martha Evaline Chapin
[1.1.4.4.1.2.8.1.9.4.2.3]
b. 29 Sep 1860
12
Mary Augustine Chapin
[1.1.4.4.1.2.8.1.9.4.2.4]
b. 21 Jan 1863
12
Josephine Chapin
[1.1.4.4.1.2.8.1.9.4.2.5]
b. 4 Jul 1867
11
Luthera Chapin
[1.1.4.4.1.2.8.1.9.4.3]
b. Abt 1834
10
Betsy Taft Chapin
[1.1.4.4.1.2.8.1.9.5]
b. 14 Oct 1807 d. 21 Apr 1838
Parley Gould
b. 17 Sep 1807 d. 16 Jan 1877
11
Luthera Gould
[1.1.4.4.1.2.8.1.9.5.1]
b. 15 Jul 1833 d. 13 Oct 1862
+
Charles Barton Prentice
b. 5 Apr 1836
11
Augustine Gould
[1.1.4.4.1.2.8.1.9.5.2]
b. 18 Mar 1835
Augusta Dillingham
b. Abt 1838 d. 9 Sep 1871
12
Edward E Gould
[1.1.4.4.1.2.8.1.9.5.2.1]
b. 20 Aug 1863
12
Ida S Gould
[1.1.4.4.1.2.8.1.9.5.2.2]
b. 24 Mar 1866
10
Abigail Adams Chapin
[1.1.4.4.1.2.8.1.9.6]
b. 4 Sep 1809 d. 6 Aug 1854
Benedict Arnold Greene
b. 17 Jan 1812 d. 12 Jan 1858
11
Robert E Greene
[1.1.4.4.1.2.8.1.9.6.1]
b. 2 Mar 1845
11
Julia Amanda Greene
[1.1.4.4.1.2.8.1.9.6.2]
b. 27 Feb 1847 d. Feb 1853
11
Moses Chapin Greene
[1.1.4.4.1.2.8.1.9.6.3]
b. 15 Apr 1849 d. 1849
11
Walter Ernest Greene
[1.1.4.4.1.2.8.1.9.6.4]
b. 1850
10
Diana Maria Chapin
[1.1.4.4.1.2.8.1.9.7]
b. 9 Mar 1812 d. 23 Aug 1854
Richard Waterman
b. 4 Aug 1809 d. 1883
11
Abbie Maria Waterman
[1.1.4.4.1.2.8.1.9.7.1]
b. 29 Mar 1835 d. 1906
Johnathan West
b. 17 Dec 1817 d. 6 Mar 1895
12
Nellie Maria West
[1.1.4.4.1.2.8.1.9.7.1.1]
b. 19 Apr 1862 d. 1935 [
=>
]
12
Mary Harrison West
[1.1.4.4.1.2.8.1.9.7.1.2]
b. 7 Dec 1865
12
Charles Howard West
[1.1.4.4.1.2.8.1.9.7.1.3]
b. 1873
12
Louise Chapin West
[1.1.4.4.1.2.8.1.9.7.1.4]
b. 30 May 1876 [
=>
]
11
Louisa Chapin Waterman
[1.1.4.4.1.2.8.1.9.7.2]
b. 23 Jul 1837 d. 25 Jul 1837
11
Elizabeth Slade Waterman
[1.1.4.4.1.2.8.1.9.7.3]
b. 23 Jul 1837
11
Caroline Chapin Waterman
[1.1.4.4.1.2.8.1.9.7.4]
b. 5 Dec 1844 d. 11 Mar 1848
11
John Waterman
[1.1.4.4.1.2.8.1.9.7.5]
b. 7 Mar 1847 d. 26 Feb 1918
+
Alice Augusta Chapin
b. 12 Aug 1853
+
Caroline Davis
b. Abt 1852
11
Thomas Warner Waterman
[1.1.4.4.1.2.8.1.9.7.6]
b. 8 Jun 1849
+
Caroline Davis
b. 15 Jul 1851 d. 5 Dec 1895
11
Fannie Alice Waterman
[1.1.4.4.1.2.8.1.9.7.7]
b. 24 Oct 1851 d. 21 Sep 1853
11
Frank Arthur Waterman
[1.1.4.4.1.2.8.1.9.7.8]
b. 24 Oct 1852
+
Abbie Jane Berry
10
Moses Smeadley Chapin
[1.1.4.4.1.2.8.1.9.8]
b. 15 Aug 1816 d. 14 Nov 1819
10
Adaline Chapin
[1.1.4.4.1.2.8.1.9.9]
b. 14 May 1820 d. 1904
8
Lucy Taft
[1.1.4.4.1.2.8.2]
b. 5 Mar 1745 d. 1822
8
Silas Taft
[1.1.4.4.1.2.8.3]
b. 22 Nov 1747
8
Sarah Taft
[1.1.4.4.1.2.8.4]
b. 8 Mar 1750 d. 3 May 1811
8
Asahel Taft
[1.1.4.4.1.2.8.5]
b. 30 Jul 1752 d. Nov 1826
Rachel Alton
b. 9 Mar 1760 d. 5 Aug 1851
9
Silas Taft
[1.1.4.4.1.2.8.5.1]
b. 21 Oct 1780
9
Elizabeth Taft
[1.1.4.4.1.2.8.5.2]
b. 17 Mar 1783
9
Rachel Taft
[1.1.4.4.1.2.8.5.3]
b. Abt 1785
9
Mary Taft
[1.1.4.4.1.2.8.5.4]
b. 1787
9
Asahel J Taft
[1.1.4.4.1.2.8.5.5]
b. 1792
9
Joseph Taft
[1.1.4.4.1.2.8.5.6]
b. 15 Jun 1794
9
Sarah Taft
[1.1.4.4.1.2.8.5.7]
b. 28 Feb 1797 d. 29 Sep 1879
Wheaton W Wilson
b. 5 Aug 1787 d. 13 Jan 1874
10
Wheaton Wilson
[1.1.4.4.1.2.8.5.7.1]
b. 10 Nov 1817 d. 17 Aug 1900
10
Mary Wilson
[1.1.4.4.1.2.8.5.7.2]
b. 7 Sep 1820 d. 23 Nov 1887
10
Fanny Maria Wilson
[1.1.4.4.1.2.8.5.7.3]
b. 12 Sep 1822 d. 1900
10
Alonzo Wilson
[1.1.4.4.1.2.8.5.7.4]
b. 19 Sep 1824 d. 13 Oct 1826
10
Emily Wilson
[1.1.4.4.1.2.8.5.7.5]
b. 7 May 1827
10
Sophia Wilson
[1.1.4.4.1.2.8.5.7.6]
b. 19 Jul 1829 d. 9 Apr 1919
10
Caroline Louisa Wilson
[1.1.4.4.1.2.8.5.7.7]
b. 4 Mar 1832 d. 11 Mar 1892
10
John Wilson
[1.1.4.4.1.2.8.5.7.8]
b. 26 May 1834
10
William Walter Wilson
[1.1.4.4.1.2.8.5.7.9]
b. 8 Sep 1836 d. 31 Jul 1839
10
Wallace Warren Wilson
[1.1.4.4.1.2.8.5.7.10]
b. 28 Sep 1839 d. 22 Oct 1906
Sarah A Samson
b. 6 Dec 1842 d. 30 Apr 1915
11
Clarence Wallace Wilson
[1.1.4.4.1.2.8.5.7.10.1]
b. Jul 1861 d. 7 Feb 1904
Lizzie Mary Knapp
b. 24 Dec 1862 d. 1900
12
Stella M Wilson
[1.1.4.4.1.2.8.5.7.10.1.1]
b. 27 Jul 1883 d. 1903
11
Mable Wilson
[1.1.4.4.1.2.8.5.7.10.2]
b. 17 Mar 1865 d. 31 Mar 1873
11
William A Wilson
[1.1.4.4.1.2.8.5.7.10.3]
b. 2 Jul 1866 d. 21 Nov 1904
Nellie C Barrett
b. Jun 1868
12
Arthur William Wilson
[1.1.4.4.1.2.8.5.7.10.3.1]
b. 15 Jun 1891 d. 1 Sep 1961
12
Sarah Alberta Wilson
[1.1.4.4.1.2.8.5.7.10.3.2]
b. 17 Feb 1893 d. 1 May 1960 [
=>
]
12
Harold Elton Wilson
[1.1.4.4.1.2.8.5.7.10.3.3]
b. 21 Mar 1895 d. 6 Nov 1961
12
Lawrence Wilmer Wilson
[1.1.4.4.1.2.8.5.7.10.3.4]
b. 3 Aug 1896 d. 1 May 1964 [
=>
]
12
Florence Wilson
[1.1.4.4.1.2.8.5.7.10.3.5]
b. Aug 1897
11
Albert Wilson
[1.1.4.4.1.2.8.5.7.10.4]
b. 1870
11
Walter Gordon Wilson
[1.1.4.4.1.2.8.5.7.10.5]
b. 20 Dec 1873 d. 20 Mar 1914
Hattie E Harvey
b. 27 Sep 1875 d. 7 Feb 1906
12
Mabel Louise Wilson
[1.1.4.4.1.2.8.5.7.10.5.1]
b. 14 Aug 1896 d. 20 Jun 1899
12
Helen Elizabeth Wilson
[1.1.4.4.1.2.8.5.7.10.5.2]
b. 14 Apr 1899 d. 15 Apr 1959 [
=>
]
12
Dora Wilson
[1.1.4.4.1.2.8.5.7.10.5.3]
b. 14 Oct 1901 d. 17 Dec 1989 [
=>
]
11
Everett Wilson
[1.1.4.4.1.2.8.5.7.10.6]
b. 20 Jul 1878 d. 7 Jan 1884
11
Lena L Wilson
[1.1.4.4.1.2.8.5.7.10.7]
b. 11 Oct 1883 d. 21 Dec 1883
11
Maud E Wilson
[1.1.4.4.1.2.8.5.7.10.8]
b. 1886 d. 24 Jan 1907
Frank Barrie Baldwin
b. 30 Dec 1882 d. 26 Apr 1956
12
Harold Gilmore Baldwin
[1.1.4.4.1.2.8.5.7.10.8.1]
b. 26 Nov 1906 d. 15 Feb 1997
9
Fannie Taft
[1.1.4.4.1.2.8.5.8]
b. 14 Jan 1801 d. 3 Sep 1867
9
Emily Taft
[1.1.4.4.1.2.8.5.9]
b. 8 Mar 1803
8
Ezra Taft
[1.1.4.4.1.2.8.6]
b. 22 Dec 1752 d. Aft 1803
8
Ruth Taft
[1.1.4.4.1.2.8.7]
b. 13 May 1763
6
Samuel Thayer
[1.1.4.4.1.3]
b. 28 Mar 1696 d. 21 Jun 1764
Mary Sampson
b. Abt 1694 d. 12 Mar 1723
7
Abigail Thayer
[1.1.4.4.1.3.1]
b. 22 Aug 1718 d. 11 Mar 1774
John Partridge
b. 2 Jun 1715 d. 21 Dec 1791
8
John Partridge
[1.1.4.4.1.3.1.1]
b. Abt 1737 d. 14 May 1764
8
Asa Partridge
[1.1.4.4.1.3.1.2]
b. 24 Jul 1740 d. 10 Dec 1746
8
Joseph Partridge
[1.1.4.4.1.3.1.3]
b. 26 Oct 1742 d. 10 Oct 1746
8
Samuel Partridge
[1.1.4.4.1.3.1.4]
b. 15 Apr 1743 d. 15 Apr 1744
8
Stephen Partridge
[1.1.4.4.1.3.1.5]
b. 15 Apr 1744 d. 15 Apr 1744
8
Abigail Partridge
[1.1.4.4.1.3.1.6]
b. 26 Oct 1745 d. 20 Feb 1746
8
Micah Partridge
[1.1.4.4.1.3.1.7]
b. 20 Dec 1746 d. 20 Dec 1746
8
Abigail Allen Partridge
[1.1.4.4.1.3.1.8]
b. 23 Jan 1754 d. 12 May 1802
7
Samuel Thayer
[1.1.4.4.1.3.2]
b. 10 Jun 1721 bur. 24 Nov 1789
Sarah Farnham
b. 20 Jul 1736 d. 1778
8
Amos Thayer
[1.1.4.4.1.3.2.1]
b. 19 Aug 1757 d. 11 Jul 1838
8
Jabes Thayer
[1.1.4.4.1.3.2.2]
b. Abt 1758 d. 1778
8
Asa Thayer
[1.1.4.4.1.3.2.3]
b. 4 Oct 1761 d. 9 Apr 1828
Mary Murdock
b. 15 Jun 1764 d. 26 Jul 1844
9
Olive Thayer
[1.1.4.4.1.3.2.3.1]
b. 10 Aug 1782 d. 1865
+
Ezekial Taft
b. 21 Jan 1777 d. 24 Apr 1841
9
Clinton Thayer
[1.1.4.4.1.3.2.3.2]
b. 27 Apr 1784 d. 7 Mar 1835
9
Nancy Thayer
[1.1.4.4.1.3.2.3.3]
b. 1786 d. 1852
Arnold Taft
b. 3 Feb 1793 d. 4 Feb 1865
10
Mary Thayer
[1.1.4.4.1.3.2.3.3.1]
b. 20 Sep 1820 d. 10 Oct 1888
Nehemiah White Lee
b. 16 Mar 1819 d. 20 Apr 1890
11
Charles Arnold Lee
[1.1.4.4.1.3.2.3.3.1.1]
b. 14 Dec 1845 d. 16 May 1900
Phebe Sprague Wright
b. Feb 1844 d. 23 Apr 1916
12
Mabel Cunier Lee
[1.1.4.4.1.3.2.3.3.1.1.1]
b. 12 May 1876
12
Charles Weight Lee
[1.1.4.4.1.3.2.3.3.1.1.2]
b. 12 May 1876
11
Walter Orman Lee
[1.1.4.4.1.3.2.3.3.1.2]
b. 6 Feb 1848 d. 16 Apr 1881
Elizabeth H Monkhouse
b. 27 Oct 1846 d. 3 Jul 1895
12
Walter Nehemiah Lee
[1.1.4.4.1.3.2.3.3.1.2.1]
b. 16 Sep 1873 d. 5 Nov 1960 [
=>
]
11
Harrit Taft Lee
[1.1.4.4.1.3.2.3.3.1.3]
b. 4 May 1852 d. 8 Apr 1888
11
Joseph Newton Lee
[1.1.4.4.1.3.2.3.3.1.4]
b. 25 Feb 1864 d. Sep 1943
11
Mary Anna Elizabeth Lee
[1.1.4.4.1.3.2.3.3.1.5]
b. 30 Nov 1859 d. 29 Jun 1945
Edwin Francis Carpenter
b. 1854 d. 7 Aug 1919
12
Bertha Lee Carpenter
[1.1.4.4.1.3.2.3.3.1.5.1]
b. 26 Jun 1883 d. 10 May 1960
12
Louisa O Carpenter
[1.1.4.4.1.3.2.3.3.1.5.2]
b. 15 Oct 1886
12
Lewis Ormand Carpenter
[1.1.4.4.1.3.2.3.3.1.5.3]
b. 15 Oct 1886 d. 5 Sep 1965
12
Edith Malora Carpenter
[1.1.4.4.1.3.2.3.3.1.5.4]
b. 14 Feb 1899 d. 7 May 1986
9
Royal Thayer
[1.1.4.4.1.3.2.3.4]
b. 1787
9
Sullivan Thayer
[1.1.4.4.1.3.2.3.5]
b. 3 Apr 1792 d. 7 Nov 1865
9
Emery Thayer
[1.1.4.4.1.3.2.3.6]
b. 19 Feb 1794 d. 12 Aug 1862
9
Louis Thayer
[1.1.4.4.1.3.2.3.7]
b. 3 Oct 1796 d. 1832
9
Mary M Thayer
[1.1.4.4.1.3.2.3.8]
b. Abt 1799 d. 1885
9
Asa Thayer
[1.1.4.4.1.3.2.3.9]
b. 2 Sep 1799 d. 1871
9
Turner Thayer
[1.1.4.4.1.3.2.3.10]
b. 2 Feb 1802 d. 8 Dec 1853
9
Lovisa Thayer
[1.1.4.4.1.3.2.3.11]
b. 4 Apr 1806 d. 1828
9
Collins Thayer
[1.1.4.4.1.3.2.3.12]
b. 7 Apr 1790 d. 19 Sep 1855
Almira Taft
b. 9 Jun 1800 d. 1873
10
Adeline Thayer
[1.1.4.4.1.3.2.3.12.1]
b. 1817
10
Virginia Thayer
[1.1.4.4.1.3.2.3.12.2]
b. 1821
10
Elizabeth Thayer
[1.1.4.4.1.3.2.3.12.3]
b. 1823
10
Collins Thayer
[1.1.4.4.1.3.2.3.12.4]
b. 1825
10
Susan Thayer
[1.1.4.4.1.3.2.3.12.5]
b. 27 Dec 1826
Charles Henry Guild
b. 25 Mar 1823
11
Virginia Melora Guild
[1.1.4.4.1.3.2.3.12.5.1]
b. 22 Dec 1846 d. 17 Jul 1929
11
Charles Samuel Guild
[1.1.4.4.1.3.2.3.12.5.2]
b. 18 Oct 1848
11
Willard Temple Guild
[1.1.4.4.1.3.2.3.12.5.3]
b. 12 Feb 1855 d. 29 Jun 1855
10
Olive A Thayer
[1.1.4.4.1.3.2.3.12.6]
b. Abt 1827
10
Mary Thayer
[1.1.4.4.1.3.2.3.12.7]
b. 1828
Almarine A Gwaltney
b. 1824
11
James A Gwaltney
[1.1.4.4.1.3.2.3.12.7.1]
b. 1851
11
Ella Gwaltney
[1.1.4.4.1.3.2.3.12.7.2]
b. 9 Feb 1856 d. 1920
11
Luther Gwaltney
[1.1.4.4.1.3.2.3.12.7.3]
b. Mar 1858
Laura S Kremer
b. Dec 1859
12
Luther Thayer Gwaltney
[1.1.4.4.1.3.2.3.12.7.3.1]
b. 16 Jun 1890 d. Aug 1971
12
Howell Corbin Gwaltney
[1.1.4.4.1.3.2.3.12.7.3.2]
b. 9 Oct 1893
11
Frances Gwaltney
[1.1.4.4.1.3.2.3.12.7.4]
b. 1860
11
Georgia Gwaltney
[1.1.4.4.1.3.2.3.12.7.5]
b. Feb 1863 d. 1940
11
Susie Gwaltney
[1.1.4.4.1.3.2.3.12.7.6]
b. 1864
10
Almira Thayer
[1.1.4.4.1.3.2.3.12.8]
b. 1831 d. 1895
8
Samuel Thayer
[1.1.4.4.1.3.2.4]
b. 6 Sep 1762 d. 1830
+
Rebecca Howe
b. 4 Dec 1763 d. 17 Aug 1829
8
Loies Thayer
[1.1.4.4.1.3.2.5]
b. 15 Feb 1764 d. 1837
8
Polly Thayer
[1.1.4.4.1.3.2.6]
b. 18 Feb 1766 d. 1843
8
Eunice Thayer
[1.1.4.4.1.3.2.7]
b. 1768 d. 1841
8
Louisa Thayer
[1.1.4.4.1.3.2.8]
b. 1774 d. 1829
7
Zilphah Thayer
[1.1.4.4.1.3.3]
b. 14 Sep 1722 d. 1761
John Holbrook
b. 1 Aug 1717 d. 1773
8
Micah Holbrook
[1.1.4.4.1.3.3.1]
b. 11 Mar 1744
8
Amariah Holbrook
[1.1.4.4.1.3.3.2]
b. Abt 1745 d. 20 Jan 1817
8
John Holbrook
[1.1.4.4.1.3.3.3]
b. Jun 1748
8
Catharina Holbrook
[1.1.4.4.1.3.3.4]
b. Abt 1752 d. 1752
8
Rhoda Holbrook
[1.1.4.4.1.3.3.5]
b. 25 Aug 1758 d. 1807
7
Mary Thayer
[1.1.4.4.1.3.4]
b. 12 Feb 1723 d. 7 Aug 1764
7
Thankful Thayer
[1.1.4.4.1.3.5]
b. 4 Aug 1725 d. 10 Dec 1798
Sylvanus Holbrook
b. 13 May 1713 d. 1782
8
Sylvanus Holbrook
[1.1.4.4.1.3.5.1]
b. 21 Apr 1750 d. 1828
Mary Thayer
b. 7 Jun 1749 d. 26 May 1831
9
Phebe Holbrook
[1.1.4.4.1.3.5.1.1]
b. 16 Feb 1773 d. 25 Oct 1832
9
Ezekiel Holbrook
[1.1.4.4.1.3.5.1.2]
b. 18 Apr 1777 d. 1799
9
Joseph Holbrook
[1.1.4.4.1.3.5.1.3]
b. 6 Nov 1781
9
Polly Holbrook
[1.1.4.4.1.3.5.1.4]
b. 1783
9
Mary Holbrook
[1.1.4.4.1.3.5.1.5]
b. 16 Oct 1784 d. 15 Aug 1844
8
Ruth Holbrook
[1.1.4.4.1.3.5.2]
b. 10 Aug 1751 d. 16 May 1781
Benoni Benson
b. 11 Jul 1747 d. 1803
9
Amasa Benson
[1.1.4.4.1.3.5.2.1]
b. 25 Jan 1771 d. 7 Mar 1837
Levina Turtilot
b. 20 Feb 1777 d. 1 May 1865
10
Henry Holbrook Benson
[1.1.4.4.1.3.5.2.1.1]
b. 22 Mar 1801
Almira A
b. 26 Aug 1817
11
Leander A Benson
[1.1.4.4.1.3.5.2.1.1.1]
b. 1838 d. 10 Aug 1839
11
Henry A Benson
[1.1.4.4.1.3.5.2.1.1.2]
b. 23 Feb 1843 d. 19 Aug 1844
11
Seth Hall Benson
[1.1.4.4.1.3.5.2.1.1.3]
b. 6 Jul 1847 d. 1915
11
Edwin Benson
[1.1.4.4.1.3.5.2.1.1.4]
b. Abt 1851
10
James Davis Benson
[1.1.4.4.1.3.5.2.1.2]
b. 15 Nov 1802 d. 5 Sep 1805
10
Chloe Benson
[1.1.4.4.1.3.5.2.1.3]
b. 2 Oct 1804 d. 28 Mar 1844
Horace B Robbins
b. 28 Mar 1797 d. 24 Feb 1879
11
Alvin Cook Robbins
[1.1.4.4.1.3.5.2.1.3.1]
b. 12 May 1828
Mary L W Meggett
b. 1830
12
Mary E Robbins
[1.1.4.4.1.3.5.2.1.3.1.1]
b. Abt 1857
12
Arthur M Robbins
[1.1.4.4.1.3.5.2.1.3.1.2]
b. Abt 1858
12
Jennie T Robbins
[1.1.4.4.1.3.5.2.1.3.1.3]
b. Sep 1860
12
Annette C Robbins
[1.1.4.4.1.3.5.2.1.3.1.4]
b. Abt 1863
12
Wallace A Robbins
[1.1.4.4.1.3.5.2.1.3.1.5]
b. Dec 1869
11
Ann Mariah Robbins
[1.1.4.4.1.3.5.2.1.3.2]
b. 6 Jul 1830
11
Henry Davis Robbins
[1.1.4.4.1.3.5.2.1.3.3]
b. 22 Sep 1834
11
Charles W Robbins
[1.1.4.4.1.3.5.2.1.3.4]
b. Abt 1837
11
Sanford Augustus Robbins
[1.1.4.4.1.3.5.2.1.3.5]
b. 9 May 1840
10
Maria R Benson
[1.1.4.4.1.3.5.2.1.4]
b. 17 Dec 1806
Alvin Cook
b. 1805 d. 9 Jun 1872
11
Ellen L Cook
[1.1.4.4.1.3.5.2.1.4.1]
b. 1830
11
Miriam A Cook
[1.1.4.4.1.3.5.2.1.4.2]
b. Oct 1834 d. 24 Mar 1835
11
Aaron Cook
[1.1.4.4.1.3.5.2.1.4.3]
b. 26 Jun 1837
11
Samantha Maria Cook
[1.1.4.4.1.3.5.2.1.4.4]
b. Abt 1841
Caleb Edmund Thayer
b. 3 Sep 1841 d. 27 Aug 1868
12
Florence Thayer
[1.1.4.4.1.3.5.2.1.4.4.1]
b. Apr 1868
11
Alice Salina Cook
[1.1.4.4.1.3.5.2.1.4.5]
b. 26 Feb 1844
11
Winfield E Cook
[1.1.4.4.1.3.5.2.1.4.6]
b. 21 Jun 1847
11
Ellen Louisa Cooke
[1.1.4.4.1.3.5.2.1.4.7]
c. 3 Sep 1843
10
Charles Holbrook Benson
[1.1.4.4.1.3.5.2.1.5]
b. 14 Sep 1809
+
Adaline M Hayward
b. 22 Feb 1823
10
Angeline Benson
[1.1.4.4.1.3.5.2.1.6]
b. 20 Jul 1811
10
Ann Eliza Benson
[1.1.4.4.1.3.5.2.1.7]
b. 20 Feb 1813
10
Elsa T Benson
[1.1.4.4.1.3.5.2.1.8]
b. 17 Jul 1815
10
Nathan Benson
[1.1.4.4.1.3.5.2.1.9]
b. 30 Nov 1817
10
William Hall Benson
[1.1.4.4.1.3.5.2.1.10]
b. 24 Oct 1819
9
Chloe Benson
[1.1.4.4.1.3.5.2.2]
b. 28 Jan 1774
9
Benoni Benson
[1.1.4.4.1.3.5.2.3]
b. 1780 d. 1819
8
Rachel Holbrook
[1.1.4.4.1.3.5.3]
b. 6 Nov 1753 d. 9 Mar 1832
Jonathan Staples
b. 29 Mar 1754 d. 28 Nov 1832
9
Sally Staples
[1.1.4.4.1.3.5.3.1]
b. 3 Oct 1779
9
Sylvia Staples
[1.1.4.4.1.3.5.3.2]
b. 2 Jan 1781 d. 13 Mar 1852
9
Rachael Staples
[1.1.4.4.1.3.5.3.3]
b. Abt 1784 d. 12 Dec 1870
9
Ellery Staples
[1.1.4.4.1.3.5.3.4]
b. 1784 d. 1861
9
Willard Staples
[1.1.4.4.1.3.5.3.5]
b. 20 Dec 1785 d. 20 Dec 1858
9
Jonathan Staples
[1.1.4.4.1.3.5.3.6]
b. 1792
8
Comfort Holbrook
[1.1.4.4.1.3.5.4]
b. 12 Mar 1756
8
Margaret Holbrook
[1.1.4.4.1.3.5.5]
b. 14 Aug 1757 d. Abt 1805
Thadaus Thayer
b. 1 Feb 1754 d. 24 Dec 1826
9
George Thayer
[1.1.4.4.1.3.5.5.1]
b. 20 Jul 1779 d. 27 May 1836
9
Otis Thayer
[1.1.4.4.1.3.5.5.2]
b. 17 Mar 1780 d. 13 Apr 1841
9
Arkey Thayer
[1.1.4.4.1.3.5.5.3]
b. 6 Dec 1781 d. 1783
9
Ellis Holbrook Thayer
[1.1.4.4.1.3.5.5.4]
b. 9 Mar 1783 d. 2 Jul 1863
9
Ruth Thayer
[1.1.4.4.1.3.5.5.5]
b. Abt 1784 d. 1821
9
Sylvanus Thayer
[1.1.4.4.1.3.5.5.6]
b. Abt 1786 d. 7 Mar 1859
9
Margaret Thayer
[1.1.4.4.1.3.5.5.7]
b. 11 Nov 1787
9
Thaddeus Thayer
[1.1.4.4.1.3.5.5.8]
b. Nov 1789 d. 4 Mar 1824
9
Margery Thayer
[1.1.4.4.1.3.5.5.9]
b. 2 May 1792
9
Maranda Thayer
[1.1.4.4.1.3.5.5.10]
b. Abt 1794
9
Barbara Thayer
[1.1.4.4.1.3.5.5.11]
b. 25 Jun 1797 d. 1822
9
Diana Thayer
[1.1.4.4.1.3.5.5.12]
b. 6 Jan 1800 d. 17 Nov 1861
8
Thankful Holbrook
[1.1.4.4.1.3.5.6]
b. 23 Feb 1760 d. 25 May 1834
David Legg
b. 11 May 1756 d. 25 Apr 1844
9
Thankful Holbrook Legg
[1.1.4.4.1.3.5.6.1]
b. Abt 1803
8
Mary Holbrook
[1.1.4.4.1.3.5.7]
b. 1 Feb 1762 d. 27 Dec 1814
John Benson
b. 1 Aug 1749 d. 18 May 1818
9
John Perry Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1]
b. 22 Jul 1781 d. 21 Jan 1842
Chloe Taft
b. 7 Jul 1785 d. 25 Apr 1826
10
Charlotte Taft Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.1]
b. 30 Sep 1807 d. 16 Jul 1878
Moses Dyer
b. 1803 d. Aft 1841
11
Merril B Dyer
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.1.1]
b. 2 Apr 1844 d. 2 Apr 1859
11
George Franklin Dyer
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.1.2]
b. 22 Jan 1846 d. 27 Feb 1917
Ellen Jane Hubbard
b. 1848 d. 1925
12
Merrill Eugene Dyer
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.1.2.1]
b. 18 Dec 1869 d. 1926 [
=>
]
11
Chloe Allice Dyer
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.1.3]
b. 5 May 1848 d. 1932
Sanford Brown
b. 10 Feb 1844 d. 1883
12
Charlotta B Brown
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.1.3.1]
b. 22 Feb 1871
12
Paul Brown
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.1.3.2]
b. 12 Jan 1873 d. 24 Nov 1952 [
=>
]
12
Sanford Brown
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.1.3.3]
b. 17 Mar 1876 d. 5 Sep 1905
12
Elizabeth Brown
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.1.3.4]
b. 25 May 1879
12
Neil Brown
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.1.3.5]
b. 25 Mar 1882 d. 5 Nov 1913
11
Angelne A Dyer
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.1.4]
b. 6 Sep 1852
Orison J Batchelor
b. 11 Jul 1851 d. 10 Jan 1913
12
Chloe Edith Bachelor
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.1.4.1]
b. 11 Sep 1873
12
Nina F Bachelor
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.1.4.2]
b. 30 Nov 1875
12
Maria Frances Bachelor
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.1.4.3]
b. 30 Nov 1875
10
Ezra Taft Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2]
b. 22 Feb 1811 d. 3 Sep 1869
Pamelia Andrus
b. 21 Oct 1809 d. 14 Sep 1877
11
Charles Agustus Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.1]
b. 26 Sep 1832 d. 14 Oct 1833
11
Chloe Jane Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.2]
b. 1835 d. 1835
11
Charles Augustus Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.3]
b. 9 Jul 1837 d. 18 Feb 1873
11
Jonathan Parsons Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.4]
b. Mar 1841 d. Mar 1841
11
Adin Parsons Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.5]
b. Mar 1841 d. Mar 1841
11
Pamelia Emma Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.6]
b. 28 Feb 1842 d. 10 Feb 1892
11
Harvey Andrus Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.7]
b. 26 Sep 1844 d. 26 Sep 1844
11
Isabella Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.8]
b. 9 Mar 1846 d. 10 Feb 1922
11
Charlotte Taft Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.9]
b. 4 Jul 1850 d. 30 Nov 1918
Winfield Scott Norcross
b. 16 Jul 1844 d. 7 Jan 1915
12
Irving Norcross
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.9.1]
b. 1880
12
Winfield Irvin Norcross
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.9.2]
b. 18 Jun 1884
Adeline Brooks Andrus
b. 18 Mar 1813 d. 20 Apr 1898
11
George Taft Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.10]
b. 1 May 1846 d. 16 May 1919
Louisa Alexandrine Ballif
b. 25 Feb 1850 d. 7 Feb 1922
12
Louisa "Lulu" Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.10.1]
b. 28 Mar 1869 d. 15 Jul 1938 [
=>
]
12
Ezra Taft Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.10.2]
b. 6 Aug 1871 d. 28 Aug 1871
12
Elise Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.10.3]
b. 10 Mar 1873 d. 22 Aug 1937 [
=>
]
12
George Taft Benson, Jr
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.10.4]
b. 24 Jun 1875 d. 13 Aug 1934 [
=>
]
12
Serge Ballif Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.10.5]
b. 2 Oct 1877 d. 18 Jan 1959 [
=>
]
12
Adeline Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.10.6]
b. 31 Jul 1879 d. 27 Jan 1960 [
=>
]
12
Florence Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.10.7]
b. 31 Jul 1879 d. 5 Nov 1967 [
=>
]
12
William Kennedy Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.10.8]
b. 9 Feb 1882 d. 28 Feb 1882
12
Frank Taft Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.10.9]
b. 23 Apr 1883 d. 19 Feb 1923 [
=>
]
12
Marie Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.10.10]
b. 19 Jul 1885 d. 6 Mar 1891
12
Carmen Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.10.11]
b. 7 Nov 1887 d. 5 Jul 1974 [
=>
]
12
Jenny Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.10.12]
b. 30 Jun 1890 d. 12 Jul 1970 [
=>
]
12
Kathinka "Kinnie" Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.10.13]
b. 15 Mar 1894 d. 20 May 1960 [
=>
]
11
Florence Adeline Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.11]
b. 17 Sep 1851 d. 25 Dec 1852
11
Nellie Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.12]
b. 30 Nov 1851 d. 24 Jan 1885
11
Frank Andrus Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.13]
b. 16 Oct 1853 d. 5 May 1937
Amanda Charlotta Eliason
b. 4 Jun 1861 d. 12 Mar 1922
12
Eva A Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.13.1]
b. 6 Jul 1882 d. 10 Aug 1946
12
Blanche Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.13.2]
b. 7 May 1888 d. 12 Sep 1979
12
Edna Mae Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.13.3]
b. 19 Oct 1890 d. 19 Mar 1976
12
Frank Andrus Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.13.4]
b. 30 Apr 1895 d. 18 Dec 1968
12
Eleanora Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.13.5]
b. 30 Nov 1896 d. 2 Oct 1992
12
Karl Eliason Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.13.6]
b. 21 Apr 1899 d. 21 Oct 1980
12
Adeline Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.13.7]
b. 14 Mar 1904 d. 5 May 1904
12
George Taft Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.13.8]
b. 17 Aug 1905 d. 18 Feb 1942
11
Samuel Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.14]
b. 1853
Eliza Ann Perry
b. 30 Mar 1828 d. 30 Apr 1913
11
Alice Eliza Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.15]
b. 11 Aug 1848 d. 3 Jun 1923
11
John Perry Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.16]
b. 24 Sep 1849 d. 4 Jan 1921
11
Malina Adelaide Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.17]
b. 21 Sep 1851 d. 31 Jul 1918
11
Orrin William Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.18]
b. 4 Oct 1853 d. 17 May 1917
11
Carrie Stella Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.19]
b. 22 May 1860 d. 15 Mar 1928
11
Abbie Della Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.20]
b. 16 Oct 1862 d. 22 Oct 1925
11
Grace Ann Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.21]
b. 31 Jan 1867 d. 15 Dec 1924
Elizabeth Gollaher
b. 30 Dec 1831 d. 4 May 1904
11
Fredrick Gollaher Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.22]
b. 17 Jan 1855 d. 6 Jan 1915
11
Brigham Young Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.23]
b. 17 Dec 1858 d. 11 Jul 1938
11
Luella Gollaher Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.24]
b. 12 Nov 1860 d. 22 Jul 1881
11
William C Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.25]
b. 11 Nov 1862 d. Sep 1937
11
Hyrum Smith Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.26]
b. 3 May 1864 d. 4 May 1935
11
Edith Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.27]
b. 22 Apr 1867 d. 11 Feb 1925
11
Lizzie Gollaher Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.28]
b. 9 Jul 1869 d. 30 Jul 1946
Olive Mary Knight
b. 24 Jan 1830 d. 27 Mar 1905
11
Louisa Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.29]
b. 29 Jun 1852 d. 29 Nov 1878
11
Heber Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.30]
b. Abt 1860 d. Bef 1868
11
Moroni Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.31]
b. 5 Nov 1861 d. 8 Jan 1934
11
Lorenzo Taft Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.32]
b. 3 Aug 1863 d. 6 Nov 1950
11
Joseph Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.33]
b. 13 Jul 1865 d. 5 Jun 1941
11
Ida May Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.34]
b. 16 Apr 1867 d. 30 Jun 1929
11
Don Carlos Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.35]
b. 29 Sep 1869 d. 19 Jan 1935
Mary Marie Larsen
b. 19 Dec 1843 d. 21 Feb 1926
11
Walter Taft Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.36]
b. 17 Jun 1867 d. 6 Jun 1957
11
Henry Taft Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.2.37]
b. 19 Mar 1869 d. 24 Feb 1947
+
Desdemona Wadsworth Fullmer
b. 6 Oct 1809 d. 9 Feb 1886
+
Lucinda Burton
b. 22 Oct 1825 d. 1 Oct 1863
10
George Taft Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.3]
b. Abt 1813
Prudence Maria Gifford
b. Abt 1815
11
Walter Everet Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.3.1]
b. 13 Sep 1857 d. 29 Apr 1907
Laura Frances Caldwell
b. 1862
12
Laura Livice Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.3.1.1]
b. 9 Oct 1883 d. 14 Feb 1911 [
=>
]
12
George T Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.3.1.2]
b. Feb 1885
10
Hannah Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.4]
b. 18 Sep 1816
Henry Dodge
b. 15 Dec 1812 d. 22 Jun 1883
11
John M Dodge
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.4.1]
b. 1838 d. 14 Feb 1898
11
Abbie R Dodge
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.4.2]
b. 1850 d. 27 Sep 1916
John Averell
b. 1846 d. 19 Aug 1895
12
Elizabeth Alice Averell
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.4.2.1]
b. 13 Apr 1884 d. 4 Feb 1901
+
William Cotter Ball
b. 1865
10
Abbie Ann Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.5]
b. Abt 1809 d. 21 Sep 1883
Calvin Rawson
b. 13 May 1797 d. 21 Jan 1868
11
Son Rawson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.5.1]
b. Abt 1828 d. Abt 1838
10
John M Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.1.6]
b. 1819 d. 12 Aug 1829
9
George Washington Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.2]
b. 25 May 1783 d. 10 Nov 1855
Alinda Warfield
b. 24 Aug 1785 d. 25 Apr 1841
10
Otis Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.2.1]
b. 28 Feb 1806 d. 16 Feb 1811
10
Harrison Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.2.2]
b. 10 Oct 1820 d. 25 Oct 1859
Marilla Adams
b. 12 Apr 1818 d. 16 Oct 1876
11
George Otis Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.2.2.1]
b. 24 Aug 1846 d. 2 May 1897
11
Reuben Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.2.2.2]
b. 1 Jan 1856 d. 25 Jul 1922
+
Marietta Ingraham Bliss
b. 27 Jun 1856 d. 21 Oct 1931
9
Jared Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.3]
b. 3 Feb 1785 d. 31 Jul 1854
Salley Taft
b. 21 Oct 1787 d. 7 Aug 1855
10
James Sulliven Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.3.1]
b. 19 Sep 1808 d. 3 Jan 1833
10
Putman Taft Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.3.2]
b. 28 Oct 1814 d. 24 Apr 1834
10
Jared Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.3.3]
b. 8 Nov 1821 d. 18 May 1894
Martha Taft
b. 23 Feb 1826 d. 19 Feb 1903
11
Sullivan Theodore Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.3.3.1]
b. 20 Apr 1844 d. 21 Sep 1911
11
Jared Irving Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.3.3.2]
b. 6 Oct 1846 d. 1919
Jenny Aiken Guild
b. 1852 d. 27 Oct 1906
12
Jared Curtis Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.3.3.2.1]
b. 6 Oct 1877
12
Frank Theodore Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.3.3.2.2]
b. 25 Feb 1878 d. Jul 1949 [
=>
]
11
Walter Bryant Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.3.3.3]
b. 16 Jan 1850 d. 10 Feb 1860
11
Grace Sally Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.3.3.4]
b. 2 Sep 1852 d. 25 Feb 1863
10
Sylvanus Holbrook Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.3.4]
b. 23 Jun 1828 d. 1878
Laurett V Howard
b. 1830 d. 1860
11
Ellen Laura Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.3.4.1]
b. 18 Aug 1851
George Hawes Lapham
b. 12 Jul 1849
12
Hattie Cobb Lapham
[1.1.4.4.1.3.5.7.3.4.1.1]
b. 21 Oct 1873 d. 13 Jun 1906
12
Albert Francis Lapham
[1.1.4.4.1.3.5.7.3.4.1.2]
b. 11 Dec 1876 [
=>
]
12
Frank Atwood Lapham
[1.1.4.4.1.3.5.7.3.4.1.3]
b. 2 Oct 1878
12
Frederick Lapham
[1.1.4.4.1.3.5.7.3.4.1.4]
b. 2 Sep 1880
12
Daughter Lapham
[1.1.4.4.1.3.5.7.3.4.1.5]
b. 19 Nov 1882
12
William Lapham
[1.1.4.4.1.3.5.7.3.4.1.6]
b. 29 Apr 1884 d. Bef 1890
12
Teresa Lapham
[1.1.4.4.1.3.5.7.3.4.1.7]
b. 10 Dec 1886
12
William Lapham
[1.1.4.4.1.3.5.7.3.4.1.8]
b. 5 Nov 1890 d. 24 May 1898
11
Ernest S Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.3.4.2]
b. 25 May 1855
+
Ida Cornelia Furbish
b. 1858
11
Laurett Victoria Howard Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.3.4.3]
b. 1859 d. 3 Jul 1883
Ezra Hunt Bailey
b. 23 Dec 1853 d. 3 May 1929
12
Edith L Bailey
[1.1.4.4.1.3.5.7.3.4.3.1]
b. 19 Jan 1881 d. 1962
Lottie E. Kelly
11
Lottie E. Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.3.4.4]
b. 20 Sep 1866
9
Abigail Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.4]
b. 13 Feb 1787
Putman Taft
b. 5 Aug 1783 d. 20 Feb 1810
10
Mary Ann Taft
[1.1.4.4.1.3.5.7.4.1]
b. 23 Oct 1807
+
Samuel T Holroyd
b. 1791 d. 4 Nov 1817
+
Angel Sweet
b. 7 Apr 1790 d. 28 Apr 1825
+
Edward Ide Bower
+
Joseph McDermott
9
Mary "Polly" Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.5]
b. 9 Jun 1788 d. 12 Jan 1864
Bailey Legg
b. 9 May 1783 d. 11 Oct 1862
10
Sylvanus B Legg
[1.1.4.4.1.3.5.7.5.1]
b. 20 Jun 1813 d. Bef 8 Jun 1885
10
Mary H Legg
[1.1.4.4.1.3.5.7.5.2]
b. 7 Jul 1815
10
Harriet H Legg
[1.1.4.4.1.3.5.7.5.3]
b. 14 Jun 1817
9
Phyba Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.6]
b. Abt 1790
9
Prudence Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.7]
b. 7 Jul 1795
9
Thankful Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.8]
b. 26 Nov 1799 d. 1 May 1852
Joseph Bartlett Cook
b. 3 Dec 1796 d. 6 Oct 1856
10
William Walker Cook
[1.1.4.4.1.3.5.7.8.1]
b. 21 Mar 1820
Nancy Marion Draper
b. 17 Mar 1823
11
Edwin L Cook
[1.1.4.4.1.3.5.7.8.1.1]
b. 29 Mar 1857
+
Elisabeth M Campbell
b. Abt 1848
10
Amanda Melvina Cook
[1.1.4.4.1.3.5.7.8.2]
b. 12 Oct 1821
10
Mary Adeliza Cook
[1.1.4.4.1.3.5.7.8.3]
b. 18 Apr 1824
10
Emily Caroline Cook
[1.1.4.4.1.3.5.7.8.4]
b. 8 Feb 1826 d. 7 Mar 1826
10
Elma Ann Cook
[1.1.4.4.1.3.5.7.8.5]
b. 29 Jan 1827 d. 13 Jan 1870
William Gibbs Comstock
b. 3 Feb 1827 d. 29 Apr 1914
11
Alice Ardella Comstock
[1.1.4.4.1.3.5.7.8.5.1]
b. 10 Dec 1850 d. 20 Sep 1914
Sandford Phipps
b. 25 Aug 1850 d. 1919
12
Ross Elliot Phipps
[1.1.4.4.1.3.5.7.8.5.1.1]
b. 3 Sep 1877 d. 31 May 1958 [
=>
]
12
Edith Ardella Phipps
[1.1.4.4.1.3.5.7.8.5.1.2]
b. 12 Sep 1879
12
George Curtis Phipps
[1.1.4.4.1.3.5.7.8.5.1.3]
b. 25 Feb 1882 d. 4 Aug 1962
11
Fanny Amanda Comstock
[1.1.4.4.1.3.5.7.8.5.2]
b. 4 Jul 1854 d. 2 Sep 1934
9
Sulvanus Holbrook Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.9]
b. 12 Jan 1797 d. 24 Aug 1812
9
Judson Benson
[1.1.4.4.1.3.5.7.10]
b. Abt 1801 d. 15 Oct 1813
8
Stephen Holbrook
[1.1.4.4.1.3.5.8]
b. 19 Jun 1764 d. 16 Aug 1830
Hope Albee
b. Abt 1765 d. 18 Jan 1840
9
Rachel Holbrook
[1.1.4.4.1.3.5.8.1]
b. 22 Apr 1789
9
Sylvanus Holbrook
[1.1.4.4.1.3.5.8.2]
b. 28 Jul 1792 d. 9 Dec 1855
9
Willard Holbrook
[1.1.4.4.1.3.5.8.3]
b. 7 Apr 1795 d. 4 Mar 1862
9
Wilder Holbrook
[1.1.4.4.1.3.5.8.4]
b. 7 Apr 1795 d. 2 Jan 1855
9
Chloe Holbrook
[1.1.4.4.1.3.5.8.5]
b. 13 Aug 1801 d. 11 Aug 1855
9
Henry Holbrook
[1.1.4.4.1.3.5.8.6]
b. 19 Apr 1804 d. 10 Jul 1874
9
Ellery Holbrook
[1.1.4.4.1.3.5.8.7]
b. 26 Jun 1810 d. 10 Jul 1847
8
Abigail Holbrook
[1.1.4.4.1.3.5.9]
b. 13 Sep 1765
8
Henry Holbrook
[1.1.4.4.1.3.5.10]
b. 11 Feb 1768 d. 18 Dec 1868
+
Barbara Thayer
b. 27 Feb 1770
8
Lucy Holbrook
[1.1.4.4.1.3.5.11]
b. 13 Sep 1770 d. 29 Jan 1843
Abner Adams
b. 4 Nov 1757 d. Aft 1831
9
Silvanus Adams
[1.1.4.4.1.3.5.11.1]
b. 7 Oct 1796 d. 6 Feb 1872
9
Washington Adams
[1.1.4.4.1.3.5.11.2]
b. 11 Dec 1799
9
Ruth Adams
[1.1.4.4.1.3.5.11.3]
b. 11 May 1802
9
Harriet Thayer Adams
[1.1.4.4.1.3.5.11.4]
b. 8 Oct 1804 d. 29 Oct 1825
9
Abner Adams
[1.1.4.4.1.3.5.11.5]
b. 11 Feb 1806
9
Judson Adams
[1.1.4.4.1.3.5.11.6]
b. 23 Mar 1808 d. 1843
9
Washington Adams
[1.1.4.4.1.3.5.11.7]
b. 1810
9
Zebediah Adams
[1.1.4.4.1.3.5.11.8]
b. 3 Aug 1814 d. 3 Apr 1815
7
Comfort Thayer
[1.1.4.4.1.3.6]
b. 28 Jul 1728 bur. 17 Oct 1761
+
Samuel Fish
b. Abt 1728
7
Margaret Thayer
[1.1.4.4.1.3.7]
b. 20 Mar 1730
Jonathan Farnham
b. 21 Apr 1739 d. 4 Mar 1816
8
Oliver Farnham
[1.1.4.4.1.3.7.1]
b. Dec 1753
7
Susanna Thayer
[1.1.4.4.1.3.8]
b. 14 Sep 1731
Elisha Hale
b. 11 Jan 1728 d. 6 Oct 1809
8
James Hale
[1.1.4.4.1.3.8.1]
b. 16 Feb 1753
8
Simeon Hale
[1.1.4.4.1.3.8.2]
b. 6 Mar 1756
7
Stephen Thayer
[1.1.4.4.1.3.9]
b. 26 Sep 1733
Rachel Davis
b. 29 Dec 1741 d. 14 Jan 1816
8
Philidelphia Thayer
[1.1.4.4.1.3.9.1]
b. 10 Nov 1763 d. 1843
8
Phylidelphia Thayer
[1.1.4.4.1.3.9.2]
b. 10 Nov 1763 d. 1843
8
Nathan Thayer
[1.1.4.4.1.3.9.3]
b. 22 Dec 1763 d. 1 May 1812
8
Stephen Thayer
[1.1.4.4.1.3.9.4]
b. 14 Mar 1765 d. 3 Mar 1819
8
Rachel Thayer
[1.1.4.4.1.3.9.5]
b. 1769
8
Nancy Thayer
[1.1.4.4.1.3.9.6]
b. 24 May 1771 d. 27 May 1822
8
Limon Alanson Thayer
[1.1.4.4.1.3.9.7]
b. 1772
8
Dolinda Thayer
[1.1.4.4.1.3.9.8]
b. 13 Apr 1774
8
Nahum Thayer
[1.1.4.4.1.3.9.9]
b. Abt 1776 d. 1811
8
Windsor Thayer
[1.1.4.4.1.3.9.10]
b. 21 Jun 1778
8
Aaron Chance Thayer
[1.1.4.4.1.3.9.11]
b. 29 Jan 1780 d. 27 Jul 1856
8
Lucinda Thayer
[1.1.4.4.1.3.9.12]
b. 1 Jan 1782 d. 5 Nov 1828
7
Olive Thayer
[1.1.4.4.1.3.10]
b. Abt 1735
+
Farnum
b. Abt 1731 d. Abt 1757
6
Temperance Thayer
[1.1.4.4.1.4]
b. 7 Jul 1698 d. 7 Apr 1760
6
David Thayer
[1.1.4.4.1.5]
b. 8 Feb 1700 d. Abt 7 Nov 1750
6
Elizabeth Thayer
[1.1.4.4.1.6]
b. 2 Mar 1703 d. 8 Aug 1747
William White
b. 10 Nov 1696 d. 1745
7
Huldah White
[1.1.4.4.1.6.1]
b. 27 Aug 1722 d. Jul 1769
7
Lydia White
[1.1.4.4.1.6.2]
b. 1 Mar 1726
Abraham Staples
b. 3 Apr 1706 d. Aug 1767
8
Deborah Staples
[1.1.4.4.1.6.2.1]
b. 1741
8
Isaac Staples
[1.1.4.4.1.6.2.2]
b. 9 Mar 1742 d. 29 May 1848
Esther Benson
b. 8 Dec 1768 d. 31 Mar 1855
9
Esther Staples
[1.1.4.4.1.6.2.2.1]
b. Abt 1790 d. 17 May 1878
9
Abraham Staples
[1.1.4.4.1.6.2.2.2]
b. 12 Mar 1792 d. 5 Sep 1881
9
Scammel Staples
[1.1.4.4.1.6.2.2.3]
b. 29 Dec 1798 d. 5 Apr 1883
9
Warren Staples
[1.1.4.4.1.6.2.2.4]
b. 17 Jan 1802
9
Evaline Staples
[1.1.4.4.1.6.2.2.5]
b. 11 Aug 1807 d. 2 Oct 1858
8
Ruth Staples
[1.1.4.4.1.6.2.3]
b. 11 Jan 1744 d. 15 Dec 1819
8
Hammutal Staples
[1.1.4.4.1.6.2.4]
b. 16 Sep 1753
8
Nahor Staples
[1.1.4.4.1.6.2.5]
b. 3 Feb 1756 d. 9 Feb 1820
7
Ruth White
[1.1.4.4.1.6.3]
b. 10 Apr 1728
7
Jemina White
[1.1.4.4.1.6.4]
b. 26 Jul 1730
7
William White
[1.1.4.4.1.6.5]
b. 22 Nov 1732 d. 8 Apr 1800
7
Son White
[1.1.4.4.1.6.6]
b. 8 Mar 1734
7
Joseph White
[1.1.4.4.1.6.7]
b. 8 Mar 1735 d. 1735
7
Mary White
[1.1.4.4.1.6.8]
b. 31 Aug 1737
7
Elizabeth White
[1.1.4.4.1.6.9]
b. 5 Oct 1740
7
Elisha White
[1.1.4.4.1.6.10]
b. 16 Jan 1742 d. 24 Jun 1811
6
John Thayer
[1.1.4.4.1.7]
b. 17 Sep 1705 d. 21 Mar 1779
6
William Thayer
[1.1.4.4.1.8]
b. 22 Jan 1707 d. 7 Dec 1769
6
Margaret Thayer
[1.1.4.4.1.9]
b. 12 Dec 1710 d. 4 Nov 1791
6
Jemima Thayer
[1.1.4.4.1.10]
b. 13 Feb 1712 d. Abt 1734
4
Dependence French
[1.1.4.5]
b. 7 Mar 1647 d. 12 Oct 1732
4
Temperance French
[1.1.4.6]
b. 30 Jan 1651 d. 12 Aug 1720
4
William French
[1.1.4.7]
b. 31 Jan 1653 d. 22 Feb 1691
4
Samuel French
[1.1.4.8]
b. 22 Feb 1660 d. 13 Oct 1718
Freedom Kingsley
b. 1624 d. 26 Jul 1689
4
Samuel French
[1.1.4.9]
b. 26 Feb 1661 d. 3 Sep 1683
3
Dorcas French
[1.1.5]
b. 31 Jul 1614 d. 30 Sep 1697
Christopher Peake
b. Abt 1612 d. 22 May 1666
4
Jonathan Peake
[1.1.5.1]
b. 17 Dec 1637 d. 2 Jun 1700
Sarah French
b. 2 Mar 1638 d. 14 Oct 1694
5
Hannah Peake
[1.1.5.1.1]
b. 10 Jan 1662 d. 1 Jun 1731
5
William Peake
[1.1.5.1.2]
b. 12 Mar 1664
5
John Peake
[1.1.5.1.3]
b. 9 Apr 1665 d. 15 Jul 1665
5
Christopher Peake
[1.1.5.1.4]
b. 9 Feb 1668 d. 9 Sep 1719
Mary Stratton
b. Abt 1670 d. Aft 1715
6
Ensign Christopher Peake
[1.1.5.1.4.1]
b. 1 Nov 1703 d. 6 Jan 1756
Rebecca Bugbee
b. 7 Mar 1707 d. 11 May 1801
7
Dorothy Peake
[1.1.5.1.4.1.1]
b. 3 Apr 1726 d. 9 Dec 1790
John Sanger
b. 1717 d. 1 Feb 1814
8
Mary Sanger
[1.1.5.1.4.1.1.1]
b. 13 Sep 1742
8
John Sanger
[1.1.5.1.4.1.1.2]
b. 2 Aug 1744
8
Dorothy Sanger
[1.1.5.1.4.1.1.3]
b. 26 Jan 1745 d. 1746
8
Huldah Sanger
[1.1.5.1.4.1.1.4]
b. 9 Aug 1747 d. 20 Feb 1795
8
Dorothy Sanger
[1.1.5.1.4.1.1.5]
b. 25 Apr 1749
8
David Sanger
[1.1.5.1.4.1.1.6]
b. 26 Apr 1751 d. 9 Jun 1796
8
Benjamin Sanger
[1.1.5.1.4.1.1.7]
b. Abt 1753 d. 28 Oct 1776
8
Alice Sanger
[1.1.5.1.4.1.1.8]
b. 10 Dec 1755 d. 8 Nov 1834
8
Zebulon Sanger
[1.1.5.1.4.1.1.9]
b. 15 Jun 1757 d. 27 Jul 1790
8
Azubah Sanger
[1.1.5.1.4.1.1.10]
b. 3 Sep 1760 d. 28 Sep 1834
8
Parley Sanger
[1.1.5.1.4.1.1.11]
b. 25 Mar 1763 d. 25 Jun 1849
8
Decaamia Sanger
[1.1.5.1.4.1.1.12]
b. 27 Dec 1764
8
Matilda Sanger
[1.1.5.1.4.1.1.13]
b. 23 Nov 1766 d. Abt 1844
8
Anna Sanger
[1.1.5.1.4.1.1.14]
b. 1767 d. Abt 1867
8
Lucinda Sanger
[1.1.5.1.4.1.1.15]
b. 6 Jul 1768 d. 21 Aug 1794
8
Irene Sanger
[1.1.5.1.4.1.1.16]
b. 14 Mar 1771 d. 10 Dec 1852
Abel Alton
b. 20 May 1767
9
Polly Alton
[1.1.5.1.4.1.1.16.1]
b. 25 Dec 1795
9
Sally Alton
[1.1.5.1.4.1.1.16.2]
b. 23 Nov 1796 d. 29 Feb 1880
Stephan A Hadlock
b. 12 Feb 1790 d. 9 Sep 1847
10
Lucretia Hadlock
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.1]
b. 17 Oct 1817 d. 1889
10
Persina Hadlock
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.2]
b. 7 Dec 1819 d. Jul 1856
10
Irene Hadlock
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.3]
b. 21 Aug 1822 d. 17 Nov 1903
10
Hathron Chauncey Hadlock
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.4]
b. 25 May 1824 d. 3 Oct 1902
10
Oren Alton Hadlock
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.5]
b. 11 Apr 1826 d. 1 Mar 1892
10
Chastina Hadlock
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.6]
b. 2 Apr 1828 d. 20 Mar 1913
10
Rosina Hadlock
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.7]
b. 15 Nov 1831 d. 3 Oct 1884
10
Sally Cecelia Hadlock
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8]
b. 23 Sep 1836 d. 30 Jun 1895
William James Hill
b. 3 Mar 1833 d. 26 Dec 1910
11
Stephen William Hill
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.1]
b. 27 Nov 1855 d. 27 Nov 1855
11
Mary Elizabeth Hill
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.2]
b. 2 Mar 1857 d. 2 Mar 1857
11
Sally Lovina Hill
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.3]
b. 25 Feb 1858 d. 29 May 1934
+
Carlos Lyon Sessions
b. 16 Jul 1842 d. 13 Apr 1926
Alma Moroni Parker
b. 9 Mar 1846 d. 30 Oct 1905
12
Lovina Parker
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.3.1]
b. 22 Feb 1892 d. 24 Aug 1963
12
Lehi Parker
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.3.2]
b. 1 Apr 1894 d. 27 Apr 1959
11
James Henry Hill
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.4]
b. 20 Feb 1860 d. 5 Jan 1917
Nancy Matilda Beckstrom
b. 4 Aug 1867 d. 24 Oct 1951
12
Nancy Elizabeth Hill
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.4.1]
b. 8 Oct 1887 d. 16 Feb 1965
12
George H Hill
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.4.2]
b. 6 May 1890 d. 11 Aug 1957
12
Sally Elnora Hill
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.4.3]
b. 21 Jul 1892 d. 17 Feb 1920
12
Annie Matilda Hill
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.4.4]
b. 16 Dec 1894 d. 1 Jan 1963
12
William Beckstrom Hill
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.4.5]
b. 9 Nov 1896 d. 27 Aug 1976
12
Mary Cilicia Hill
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.4.6]
b. 25 Jul 1899 d. 16 Aug 1980
12
Augusta Percinda Hill
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.4.7]
b. 17 Apr 1902 d. 4 Mar 1976
12
John Wilford Hill
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.4.8]
b. 29 Aug 1904 d. 5 Jan 1983
12
Charles David Hill
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.4.9]
b. 27 Nov 1906 d. 5 Jan 1907
12
Nettie Hill
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.4.10]
b. 7 May 1908 d. 27 Mar 1999
12
James Franklin Hill
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.4.11]
b. 22 Aug 1911 d. 3 Jan 1992
11
Sarah Melvina Hill
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.5]
b. 1 Apr 1862 d. 24 Mar 1892
John Clarence McKindrick
b. 19 Nov 1861 d. 17 Feb 1919
12
Sarah Cilicia McKindrick
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.5.1]
b. 7 Jul 1885 d. 6 Oct 1951
11
Henretta Augusta Hill
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.6]
b. 28 Nov 1864 d. 4 Sep 1922
Richard Lorenzo Smith
b. 18 Oct 1862 d. 13 Jul 1932
12
Lorenzo Ray Smith
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.6.1]
b. 9 Jul 1889 d. 14 Nov 1962
12
Augusta May Smith
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.6.2]
b. 18 May 1895 d. 7 Oct 1967 [
=>
]
11
George Richard Hill
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.7]
b. 18 Mar 1866 d. 16 Sep 1905
Rose Hannah Davis
b. 23 Dec 1874 d. 10 Jun 1964
12
Melvin Richard Hill
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.7.1]
b. 29 Oct 1897 d. 27 Jan 1940
12
Caroline Cecilia Hill
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.7.2]
b. 11 Dec 1899 d. 4 Aug 1973 [
=>
]
12
William James Hill
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.7.3]
b. 8 Oct 1901 d. 4 May 1985 [
=>
]
12
Lovina Hill
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.7.4]
b. 24 Dec 1904 d. 3 Apr 1966 [
=>
]
12
George Owen Hill
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.7.5]
b. 12 Apr 1906 d. 8 Aug 1981 [
=>
]
11
Rozina Emeline Hill
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.8]
b. 23 Jul 1868 d. 4 Apr 1930
Hyrum Chittenden
b. 28 May 1865 d. 27 Jun 1948
12
Rozina Louisa Chittenden
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.8.1]
b. 14 Sep 1888 d. 1954
12
Hyrum Chittenden
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.8.2]
b. 4 Jan 1891 d. Mar 1984
12
Mabel Lovina Chittenden
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.8.3]
b. 23 Jun 1892 d. 23 Oct 1918
12
William Chittenden
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.8.4]
b. 9 Jan 1895 d. 29 Oct 1918
12
Glen Chittenden
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.8.5]
b. 2 Nov 1897 d. Mar 1976
12
Roy Chittenden
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.8.6]
b. 4 Jul 1899
12
Mary Chittenden
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.8.7]
b. 11 Dec 1900 d. 25 Jun 1988
12
Alice Chittenden
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.8.8]
b. 7 Jun 1902 d. 5 Jan 1991
12
Edith Chittenden
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.8.9]
b. 9 Aug 1904 d. 6 Nov 1904
12
Bert Chittenden
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.8.10]
b. 17 Sep 1907 d. Jun 1975
12
Ella Chittenden
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.8.11]
b. 10 Feb 1909 d. 13 May 1983
12
Myrle Chittenden
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.8.12]
b. 29 Oct 1911 d. 16 Jul 1996
11
Nancy Naomi Hill
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.9]
b. 13 Feb 1873 d. 4 Mar 1930
Robert Bruce Martin
b. 15 Aug 1863 d. 23 Dec 1918
12
Richard Daniel Martin
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.9.1]
b. 18 Apr 1896 d. 23 May 1966
12
Augusta Geneva Martin
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.9.2]
b. 7 Jun 1898 d. 2 Jan 1942
12
Robert Lee Martin
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.9.3]
b. 28 Apr 1903 d. 14 Nov 1962
12
Glenn Ray Martin
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.9.4]
b. 29 Aug 1905 d. 13 Dec 1974
11
Rhoda Christina Hill
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.10]
b. 16 Apr 1875 d. 16 Apr 1926
Henry Peter Olsen
b. 23 May 1870 d. 8 May 1928
12
Cordellia Christina Olsen
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.10.1]
b. 11 Nov 1895 d. Aug 1935
12
Vernless Leroy Olsen
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.10.2]
b. 10 Sep 1898 d. 7 Jan 1970
12
Leonard Olsen
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.10.3]
b. 18 Feb 1900 d. 4 Mar 1976
12
Son Olsen
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.10.4]
b. 2 Sep 1903 d. 1903
11
Adeline Precinda Hill
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.11]
b. 3 Jun 1878 d. 1 Jun 1926
David Thomas Davis
b. 10 Feb 1872 d. 21 Apr 1958
12
Arles Thomas Davis
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.11.1]
b. 14 Oct 1898 d. 4 Jul 1957 [
=>
]
12
Iva Adeline Davis
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.11.2]
b. 8 Oct 1900 d. 5 Dec 1940 [
=>
]
12
Alta Cilicia Davis
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.11.3]
b. 11 Aug 1903 d. 5 Jun 1959 [
=>
]
12
David Rufus Davis
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.11.4]
b. 14 Jul 1906 d. 20 Jul 1962 [
=>
]
12
George Nathan Davis
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.11.5]
b. 25 Jul 1908 d. 30 Mar 1988 [
=>
]
12
James Richard Davis
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.11.6]
b. 26 Aug 1910 d. 17 Aug 1996 [
=>
]
12
Edna Sophia Davis
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.11.7]
b. 18 Aug 1912 d. 21 Mar 1938 [
=>
]
12
Woodrow Hill Davis
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.11.8]
b. 18 Mar 1918 d. 13 Apr 1973 [
=>
]
12
Dhorus Ted Davis
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.11.9]
b. 29 Oct 1921 d. 11 Apr 2014 [
=>
]
11
Louella Cilicia Hill
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.8.12]
b. 15 Aug 1880 d. 15 Aug 1880
10
Esther Adeline Hadlock
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.9]
b. 12 Feb 1841 d. 20 Dec 1913
10
Henrietta Hadlock
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10]
b. 10 Jul 1843 d. 8 Aug 1928
William James Hill
b. 3 Mar 1833 d. 26 Dec 1910
11
Sally Lodedkia Hill
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.1]
b. 28 Aug 1868 d. 29 Sep 1869
11
Rosetha Amena Hill
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.2]
b. 10 Apr 1870 d. 10 Apr 1909
11
Emily Cilicia Hill
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.3]
b. 4 Aug 1871 d. 30 Apr 1949
John Valfread Kjelstrom
b. 11 Dec 1865 d. 17 May 1955
12
James V Kjelstrom
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.3.1]
b. 6 Jun 1894 d. Dec 1946
12
Elmer Kjelstrom
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.3.2]
b. 17 Apr 1896 d. 28 Aug 1968
12
Sylvester Bramwell Kjelstrom
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.3.3]
b. 11 Oct 1897 d. 20 Jun 1982
12
Rhoda Jane Kjelstrom
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.3.4]
b. 28 Nov 1899
12
William Clarence Kjelstrom
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.3.5]
b. 14 Jan 1903
12
Henrietta Charlotte Kjelstrom
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.3.6]
b. 6 Feb 1904 d. May 1999
12
Axel Gabriel Kjelstrom
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.3.7]
b. 12 Mar 1906 d. 21 Feb 1999
12
Axel Gable Kjelstrom
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.3.8]
b. 12 May 1906 d. 21 Feb 1999 [
=>
]
12
Sarah Elizabeth Kjelstrom
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.3.9]
b. 25 Jul 1907 d. 7 Jul 2001
12
Elwood Wallace Kjelstrom
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.3.10]
b. 7 Dec 1910 d. 21 Aug 1911
11
Cynthia Clista Hill
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.4]
b. 19 Jul 1873 d. 31 Oct 1946
George Washington Dimick
b. 8 Apr 1864 d. 27 Dec 1938
12
George William Dimick
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.4.1]
b. 28 Aug 1890 d. 24 Jun 1956
12
Cynthia Lovina Dimick
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.4.2]
b. 11 Oct 1893 d. 13 Jul 1957
12
David Ephraim Dimick
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.4.3]
b. Abt 1895
12
James Albert Dimick
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.4.4]
b. 19 Apr 1897 d. 19 Aug 1977
12
Charles Alma Dimick
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.4.5]
b. 3 Nov 1898 d. Jan 1908
12
Henrietta Jane Dimick
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.4.6]
b. 22 Apr 1900 d. 27 Dec 1988
12
Thomas Jefferson Dimick
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.4.7]
b. 10 Jul 1902 d. 18 Jul 1983
12
Parley Wesley Dimick
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.4.8]
b. 16 Jan 1904 d. 23 Jan 1908
12
Robert Harold Dimick
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.4.9]
b. 7 Jul 1909 d. 10 Mar 1912
12
Frank Elden Dimick
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.4.10]
b. 4 May 1911 d. 10 Mar 1912
12
Ross Allan Dimick
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.4.11]
b. 17 Apr 1917 d. May 1991
11
Charles Sylvester Hill
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.5]
b. 11 Oct 1874 d. 15 Feb 1960
+
Florence Rawlinson
b. Abt 1878
11
Ester Marinda Hill
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.6]
b. 20 Aug 1876 d. 28 Oct 1900
William Gardner Eldredge
b. 21 Nov 1871 d. 23 Jan 1947
12
Amanda Jane Eldredge
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.6.1]
b. 18 May 1894 d. 3 Jun 1966
12
George Gardner Eldredge
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.6.2]
b. 11 Jun 1897 d. 7 Mar 1965
12
Samuel Sylvester Eldredge
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.6.3]
b. 13 Feb 1899 d. 14 Dec 1961
12
Esther Henrietta Eldredge
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.6.4]
b. 19 Oct 1900 d. 25 May 1902
11
Zina Belinda Hill
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.7]
b. 11 Oct 1877 d. 16 Feb 1965
Brigham Mon Victor Gould
b. 19 Jul 1864 d. 3 Jan 1955
12
Verda Belinda Goold
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.7.1]
b. 13 Feb 1902 d. 30 Jan 1988
12
Olive Henrietta Goold
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.7.2]
b. 26 Sep 1903 d. 31 Jul 1935
12
Brigham Mon Victor Goold
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.7.3]
b. 29 Sep 1906 d. 6 Jan 1983
12
Herald Ensign Goold
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.7.4]
b. 28 Nov 1908 d. 31 Mar 1920
12
Helen Rozeltha Goold
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.7.5]
b. 10 Aug 1910 d. 18 Feb 1948
12
Esther La Rue Goold
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.7.6]
b. 15 Apr 1913 d. 7 Feb 1991
12
Living
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.7.7]
12
Living
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.7.8]
12
William George Goold
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.7.9]
b. 2 Dec 1918 d. 8 Nov 1995
11
Henrietta Persina Hill
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.8]
b. 16 Jul 1879 d. 11 Jun 1961
+
William Seth Parks
b. Abt 1875
11
Hulda Carinda Hill
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.9]
b. 19 Oct 1881 d. 24 Mar 1953
William Marade Norton
b. 20 Jan 1873 d. 27 May 1939
12
Vivian Hulda Norton
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.9.1]
b. 3 Jun 1902 d. 16 Feb 1938
12
Florence Alena Norton
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.9.2]
b. 21 Dec 1903 d. 26 Nov 1991
12
William Dewile Norton
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.9.3]
b. 21 Dec 1905 d. 22 Jun 1989
12
Preal Norton
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.9.4]
b. 11 Mar 1908 d. 17 Jan 1918
12
Elizabeth Norton
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.9.5]
b. 14 Apr 1910 d. 10 Jul 2005
12
Bardel Norton
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.9.6]
b. 16 Aug 1912 d. 7 Jun 1996
12
Loyal H Norton
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.9.7]
b. 18 Apr 1914 d. 6 Apr 1996
12
Eva Norton
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.9.8]
b. 7 Oct 1923 d. 28 Dec 1964
11
Betty Petty Hill
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.10]
b. 4 Sep 1884 d. 18 Jun 1917
Seamon Anthony Golding
b. 6 Dec 1878 d. 16 Nov 1955
12
Bettie Romania Golding
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.10.1]
b. 16 Oct 1904 d. 26 Jun 1963
12
Semon Rex Golding
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.10.2]
b. 8 Feb 1906 d. 6 Apr 1969
12
Vera Rebecca Golding
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.10.3]
b. 3 Mar 1908 d. 18 Jun 1981
12
Elden Barton Golding
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.10.4]
b. 16 Sep 1909 d. 4 Jan 1997
12
Nida Cloe Golding
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.10.5]
b. 15 Apr 1915 d. 25 Oct 2005
12
Son Golding
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.10.6]
b. 12 Jun 1917 d. 13 Jun 1917
11
William Strait Hill
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.11]
b. 23 Feb 1886 d. 2 Jan 1985
Fanny Hamblin
b. 13 May 1897 d. 7 Jun 1957
12
James Vernon Hill
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.11.1]
b. 7 Feb 1918 d. 21 Dec 1918
12
Cora Hill
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.11.2]
b. 30 Apr 1919 d. 11 Jun 1994
12
Fanny Lamar Hill
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.11.3]
b. 2 Dec 1920 d. 21 Jan 1995
12
William Norman Hill
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.11.4]
b. 9 Apr 1923 d. 12 Jan 1999
12
Shirley Rose Hill
[1.1.5.1.4.1.1.16.2.10.11.5]
b. 8 Jan 1927 d. 12 Oct 2001
+
Helena P Christensen
b. 11 Sep 1886 d. 15 Jun 1980
9
Nancy Alton
[1.1.5.1.4.1.1.16.3]
b. 8 Dec 1798
9
Orin Alton
[1.1.5.1.4.1.1.16.4]
b. 22 Oct 1801
9
Abel Alton
[1.1.5.1.4.1.1.16.5]
b. 16 Jun 1803 d. 19 Sep 1870
9
Irene Alton
[1.1.5.1.4.1.1.16.6]
b. 25 Apr 1807 d. 10 Aug 1852
7
Eleanor Peake
[1.1.5.1.4.1.2]
b. 12 Jun 1727 d. 9 Dec 1790
7
Anna Peake
[1.1.5.1.4.1.3]
b. 26 Dec 1728
7
Mary Peake
[1.1.5.1.4.1.4]
b. 20 Aug 1730
7
Elijah Peake
[1.1.5.1.4.1.5]
b. 20 Feb 1732 d. 7 Apr 1757
7
Samuel Peake
[1.1.5.1.4.1.6]
b. 8 Jan 1733 d. Bef 1734
7
Samuel Peake
[1.1.5.1.4.1.7]
b. 15 Feb 1734
7
Moses Peake
[1.1.5.1.4.1.8]
b. 10 Aug 1736 d. 24 Feb 1763
7
Rebecca Peake
[1.1.5.1.4.1.9]
b. 15 Feb 1738 d. 22 Mar 1800
7
Alice Peake
[1.1.5.1.4.1.10]
b. 8 Feb 1740
7
Sybil Peake
[1.1.5.1.4.1.11]
b. Abt 1742
7
Lois Esther Peake
[1.1.5.1.4.1.12]
b. Abt 1744 d. Abt 1842
7
Abijah Peake
[1.1.5.1.4.1.13]
b. Abt 1746
7
Zerviah Peake
[1.1.5.1.4.1.14]
b. Abt 1748 d. Abt 28 Jan 1837
6
Mary Peake
[1.1.5.1.4.2]
b. 5 Apr 1706 d. Bef 1 Jun 1710
6
Mary Peake
[1.1.5.1.4.3]
b. 1 Jun 1710 d. 3 May 1741
6
Elizabeth Peake
[1.1.5.1.4.4]
b. 12 Aug 1712 d. 8 Nov 1733
6
Anna Peake
[1.1.5.1.4.5]
b. Abt 1714 d. Aft 1763
6
Experience Peake
[1.1.5.1.4.6]
b. 15 Feb 1715 d. 6 Jan 1797
6
John Peake
[1.1.5.1.4.7]
b. 14 Dec 1717 d. 17 Aug 1755
5
John Peake
[1.1.5.1.5]
b. 13 Apr 1670 d. 14 Jan 1690
5
Joseph Peake
[1.1.5.1.6]
b. 20 Dec 1671 d. 14 Aug 1672
5
Sarah Peake
[1.1.5.1.7]
b. 18 May 1673 d. 19 Dec 1721
5
Elizabeth Peake
[1.1.5.1.8]
b. 9 Aug 1680 d. 13 Nov 1747
5
Jonathan Peake
[1.1.5.1.9]
b. 10 Oct 1663 d. 20 Sep 1744
Hannah Leavens
b. 17 Oct 1666 d. 16 Oct 1754
6
Jane Peake
[1.1.5.1.9.1]
b. Abt 1690
6
Joseph Peake
[1.1.5.1.9.2]
b. 23 Nov 1691
6
Hannah Peake
[1.1.5.1.9.3]
b. 14 Nov 1693 d. 18 Oct 1740
6
Dorcas Peake
[1.1.5.1.9.4]
b. 27 Feb 1696 d. 19 May 1785
Nathaniel Sanger
b. 9 Dec 1684 d. 6 Jun 1761
7
Mercy Sanger
[1.1.5.1.9.4.1]
b. 29 Apr 1716 d. 1740
7
John Sanger
[1.1.5.1.9.4.2]
b. 1717 d. 1 Feb 1814
Dorothy Peake
b. 3 Apr 1726 d. 9 Dec 1790
8
Mary Sanger
[1.1.5.1.9.4.2.1]
b. 13 Sep 1742
8
John Sanger
[1.1.5.1.9.4.2.2]
b. 2 Aug 1744
8
Dorothy Sanger
[1.1.5.1.9.4.2.3]
b. 26 Jan 1745 d. 1746
8
Huldah Sanger
[1.1.5.1.9.4.2.4]
b. 9 Aug 1747 d. 20 Feb 1795
8
Dorothy Sanger
[1.1.5.1.9.4.2.5]
b. 25 Apr 1749
8
David Sanger
[1.1.5.1.9.4.2.6]
b. 26 Apr 1751 d. 9 Jun 1796
8
Benjamin Sanger
[1.1.5.1.9.4.2.7]
b. Abt 1753 d. 28 Oct 1776
8
Alice Sanger
[1.1.5.1.9.4.2.8]
b. 10 Dec 1755 d. 8 Nov 1834
8
Zebulon Sanger
[1.1.5.1.9.4.2.9]
b. 15 Jun 1757 d. 27 Jul 1790
8
Azubah Sanger
[1.1.5.1.9.4.2.10]
b. 3 Sep 1760 d. 28 Sep 1834
8
Parley Sanger
[1.1.5.1.9.4.2.11]
b. 25 Mar 1763 d. 25 Jun 1849
8
Decaamia Sanger
[1.1.5.1.9.4.2.12]
b. 27 Dec 1764
8
Matilda Sanger
[1.1.5.1.9.4.2.13]
b. 23 Nov 1766 d. Abt 1844
8
Anna Sanger
[1.1.5.1.9.4.2.14]
b. 1767 d. Abt 1867
8
Lucinda Sanger
[1.1.5.1.9.4.2.15]
b. 6 Jul 1768 d. 21 Aug 1794
8
Irene Sanger
[1.1.5.1.9.4.2.16]
b. 14 Mar 1771 d. 10 Dec 1852
Abel Alton
b. 20 May 1767
9
Polly Alton
[1.1.5.1.9.4.2.16.1]
b. 25 Dec 1795
9
Sally Alton
[1.1.5.1.9.4.2.16.2]
b. 23 Nov 1796 d. 29 Feb 1880
Stephan A Hadlock
b. 12 Feb 1790 d. 9 Sep 1847
10
Lucretia Hadlock
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.1]
b. 17 Oct 1817 d. 1889
10
Persina Hadlock
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.2]
b. 7 Dec 1819 d. Jul 1856
10
Irene Hadlock
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.3]
b. 21 Aug 1822 d. 17 Nov 1903
10
Hathron Chauncey Hadlock
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.4]
b. 25 May 1824 d. 3 Oct 1902
10
Oren Alton Hadlock
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.5]
b. 11 Apr 1826 d. 1 Mar 1892
10
Chastina Hadlock
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.6]
b. 2 Apr 1828 d. 20 Mar 1913
10
Rosina Hadlock
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.7]
b. 15 Nov 1831 d. 3 Oct 1884
10
Sally Cecelia Hadlock
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8]
b. 23 Sep 1836 d. 30 Jun 1895
William James Hill
b. 3 Mar 1833 d. 26 Dec 1910
11
Stephen William Hill
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.1]
b. 27 Nov 1855 d. 27 Nov 1855
11
Mary Elizabeth Hill
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.2]
b. 2 Mar 1857 d. 2 Mar 1857
11
Sally Lovina Hill
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.3]
b. 25 Feb 1858 d. 29 May 1934
+
Carlos Lyon Sessions
b. 16 Jul 1842 d. 13 Apr 1926
Alma Moroni Parker
b. 9 Mar 1846 d. 30 Oct 1905
12
Lovina Parker
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.3.1]
b. 22 Feb 1892 d. 24 Aug 1963
12
Lehi Parker
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.3.2]
b. 1 Apr 1894 d. 27 Apr 1959
11
James Henry Hill
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.4]
b. 20 Feb 1860 d. 5 Jan 1917
Nancy Matilda Beckstrom
b. 4 Aug 1867 d. 24 Oct 1951
12
Nancy Elizabeth Hill
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.4.1]
b. 8 Oct 1887 d. 16 Feb 1965
12
George H Hill
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.4.2]
b. 6 May 1890 d. 11 Aug 1957
12
Sally Elnora Hill
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.4.3]
b. 21 Jul 1892 d. 17 Feb 1920
12
Annie Matilda Hill
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.4.4]
b. 16 Dec 1894 d. 1 Jan 1963
12
William Beckstrom Hill
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.4.5]
b. 9 Nov 1896 d. 27 Aug 1976
12
Mary Cilicia Hill
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.4.6]
b. 25 Jul 1899 d. 16 Aug 1980
12
Augusta Percinda Hill
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.4.7]
b. 17 Apr 1902 d. 4 Mar 1976
12
John Wilford Hill
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.4.8]
b. 29 Aug 1904 d. 5 Jan 1983
12
Charles David Hill
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.4.9]
b. 27 Nov 1906 d. 5 Jan 1907
12
Nettie Hill
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.4.10]
b. 7 May 1908 d. 27 Mar 1999
12
James Franklin Hill
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.4.11]
b. 22 Aug 1911 d. 3 Jan 1992
11
Sarah Melvina Hill
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.5]
b. 1 Apr 1862 d. 24 Mar 1892
John Clarence McKindrick
b. 19 Nov 1861 d. 17 Feb 1919
12
Sarah Cilicia McKindrick
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.5.1]
b. 7 Jul 1885 d. 6 Oct 1951
11
Henretta Augusta Hill
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.6]
b. 28 Nov 1864 d. 4 Sep 1922
Richard Lorenzo Smith
b. 18 Oct 1862 d. 13 Jul 1932
12
Lorenzo Ray Smith
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.6.1]
b. 9 Jul 1889 d. 14 Nov 1962
12
Augusta May Smith
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.6.2]
b. 18 May 1895 d. 7 Oct 1967 [
=>
]
11
George Richard Hill
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.7]
b. 18 Mar 1866 d. 16 Sep 1905
Rose Hannah Davis
b. 23 Dec 1874 d. 10 Jun 1964
12
Melvin Richard Hill
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.7.1]
b. 29 Oct 1897 d. 27 Jan 1940
12
Caroline Cecilia Hill
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.7.2]
b. 11 Dec 1899 d. 4 Aug 1973 [
=>
]
12
William James Hill
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.7.3]
b. 8 Oct 1901 d. 4 May 1985 [
=>
]
12
Lovina Hill
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.7.4]
b. 24 Dec 1904 d. 3 Apr 1966 [
=>
]
12
George Owen Hill
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.7.5]
b. 12 Apr 1906 d. 8 Aug 1981 [
=>
]
11
Rozina Emeline Hill
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.8]
b. 23 Jul 1868 d. 4 Apr 1930
Hyrum Chittenden
b. 28 May 1865 d. 27 Jun 1948
12
Rozina Louisa Chittenden
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.8.1]
b. 14 Sep 1888 d. 1954
12
Hyrum Chittenden
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.8.2]
b. 4 Jan 1891 d. Mar 1984
12
Mabel Lovina Chittenden
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.8.3]
b. 23 Jun 1892 d. 23 Oct 1918
12
William Chittenden
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.8.4]
b. 9 Jan 1895 d. 29 Oct 1918
12
Glen Chittenden
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.8.5]
b. 2 Nov 1897 d. Mar 1976
12
Roy Chittenden
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.8.6]
b. 4 Jul 1899
12
Mary Chittenden
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.8.7]
b. 11 Dec 1900 d. 25 Jun 1988
12
Alice Chittenden
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.8.8]
b. 7 Jun 1902 d. 5 Jan 1991
12
Edith Chittenden
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.8.9]
b. 9 Aug 1904 d. 6 Nov 1904
12
Bert Chittenden
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.8.10]
b. 17 Sep 1907 d. Jun 1975
12
Ella Chittenden
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.8.11]
b. 10 Feb 1909 d. 13 May 1983
12
Myrle Chittenden
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.8.12]
b. 29 Oct 1911 d. 16 Jul 1996
11
Nancy Naomi Hill
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.9]
b. 13 Feb 1873 d. 4 Mar 1930
Robert Bruce Martin
b. 15 Aug 1863 d. 23 Dec 1918
12
Richard Daniel Martin
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.9.1]
b. 18 Apr 1896 d. 23 May 1966
12
Augusta Geneva Martin
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.9.2]
b. 7 Jun 1898 d. 2 Jan 1942
12
Robert Lee Martin
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.9.3]
b. 28 Apr 1903 d. 14 Nov 1962
12
Glenn Ray Martin
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.9.4]
b. 29 Aug 1905 d. 13 Dec 1974
11
Rhoda Christina Hill
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.10]
b. 16 Apr 1875 d. 16 Apr 1926
Henry Peter Olsen
b. 23 May 1870 d. 8 May 1928
12
Cordellia Christina Olsen
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.10.1]
b. 11 Nov 1895 d. Aug 1935
12
Vernless Leroy Olsen
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.10.2]
b. 10 Sep 1898 d. 7 Jan 1970
12
Leonard Olsen
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.10.3]
b. 18 Feb 1900 d. 4 Mar 1976
12
Son Olsen
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.10.4]
b. 2 Sep 1903 d. 1903
11
Adeline Precinda Hill
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.11]
b. 3 Jun 1878 d. 1 Jun 1926
David Thomas Davis
b. 10 Feb 1872 d. 21 Apr 1958
12
Arles Thomas Davis
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.11.1]
b. 14 Oct 1898 d. 4 Jul 1957 [
=>
]
12
Iva Adeline Davis
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.11.2]
b. 8 Oct 1900 d. 5 Dec 1940 [
=>
]
12
Alta Cilicia Davis
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.11.3]
b. 11 Aug 1903 d. 5 Jun 1959 [
=>
]
12
David Rufus Davis
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.11.4]
b. 14 Jul 1906 d. 20 Jul 1962 [
=>
]
12
George Nathan Davis
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.11.5]
b. 25 Jul 1908 d. 30 Mar 1988 [
=>
]
12
James Richard Davis
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.11.6]
b. 26 Aug 1910 d. 17 Aug 1996 [
=>
]
12
Edna Sophia Davis
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.11.7]
b. 18 Aug 1912 d. 21 Mar 1938 [
=>
]
12
Woodrow Hill Davis
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.11.8]
b. 18 Mar 1918 d. 13 Apr 1973 [
=>
]
12
Dhorus Ted Davis
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.11.9]
b. 29 Oct 1921 d. 11 Apr 2014 [
=>
]
11
Louella Cilicia Hill
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.8.12]
b. 15 Aug 1880 d. 15 Aug 1880
10
Esther Adeline Hadlock
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.9]
b. 12 Feb 1841 d. 20 Dec 1913
10
Henrietta Hadlock
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10]
b. 10 Jul 1843 d. 8 Aug 1928
William James Hill
b. 3 Mar 1833 d. 26 Dec 1910
11
Sally Lodedkia Hill
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.1]
b. 28 Aug 1868 d. 29 Sep 1869
11
Rosetha Amena Hill
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.2]
b. 10 Apr 1870 d. 10 Apr 1909
11
Emily Cilicia Hill
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.3]
b. 4 Aug 1871 d. 30 Apr 1949
John Valfread Kjelstrom
b. 11 Dec 1865 d. 17 May 1955
12
James V Kjelstrom
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.3.1]
b. 6 Jun 1894 d. Dec 1946
12
Elmer Kjelstrom
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.3.2]
b. 17 Apr 1896 d. 28 Aug 1968
12
Sylvester Bramwell Kjelstrom
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.3.3]
b. 11 Oct 1897 d. 20 Jun 1982
12
Rhoda Jane Kjelstrom
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.3.4]
b. 28 Nov 1899
12
William Clarence Kjelstrom
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.3.5]
b. 14 Jan 1903
12
Henrietta Charlotte Kjelstrom
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.3.6]
b. 6 Feb 1904 d. May 1999
12
Axel Gabriel Kjelstrom
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.3.7]
b. 12 Mar 1906 d. 21 Feb 1999
12
Axel Gable Kjelstrom
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.3.8]
b. 12 May 1906 d. 21 Feb 1999 [
=>
]
12
Sarah Elizabeth Kjelstrom
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.3.9]
b. 25 Jul 1907 d. 7 Jul 2001
12
Elwood Wallace Kjelstrom
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.3.10]
b. 7 Dec 1910 d. 21 Aug 1911
11
Cynthia Clista Hill
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.4]
b. 19 Jul 1873 d. 31 Oct 1946
George Washington Dimick
b. 8 Apr 1864 d. 27 Dec 1938
12
George William Dimick
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.4.1]
b. 28 Aug 1890 d. 24 Jun 1956
12
Cynthia Lovina Dimick
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.4.2]
b. 11 Oct 1893 d. 13 Jul 1957
12
David Ephraim Dimick
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.4.3]
b. Abt 1895
12
James Albert Dimick
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.4.4]
b. 19 Apr 1897 d. 19 Aug 1977
12
Charles Alma Dimick
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.4.5]
b. 3 Nov 1898 d. Jan 1908
12
Henrietta Jane Dimick
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.4.6]
b. 22 Apr 1900 d. 27 Dec 1988
12
Thomas Jefferson Dimick
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.4.7]
b. 10 Jul 1902 d. 18 Jul 1983
12
Parley Wesley Dimick
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.4.8]
b. 16 Jan 1904 d. 23 Jan 1908
12
Robert Harold Dimick
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.4.9]
b. 7 Jul 1909 d. 10 Mar 1912
12
Frank Elden Dimick
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.4.10]
b. 4 May 1911 d. 10 Mar 1912
12
Ross Allan Dimick
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.4.11]
b. 17 Apr 1917 d. May 1991
11
Charles Sylvester Hill
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.5]
b. 11 Oct 1874 d. 15 Feb 1960
+
Florence Rawlinson
b. Abt 1878
11
Ester Marinda Hill
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.6]
b. 20 Aug 1876 d. 28 Oct 1900
William Gardner Eldredge
b. 21 Nov 1871 d. 23 Jan 1947
12
Amanda Jane Eldredge
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.6.1]
b. 18 May 1894 d. 3 Jun 1966
12
George Gardner Eldredge
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.6.2]
b. 11 Jun 1897 d. 7 Mar 1965
12
Samuel Sylvester Eldredge
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.6.3]
b. 13 Feb 1899 d. 14 Dec 1961
12
Esther Henrietta Eldredge
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.6.4]
b. 19 Oct 1900 d. 25 May 1902
11
Zina Belinda Hill
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.7]
b. 11 Oct 1877 d. 16 Feb 1965
Brigham Mon Victor Gould
b. 19 Jul 1864 d. 3 Jan 1955
12
Verda Belinda Goold
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.7.1]
b. 13 Feb 1902 d. 30 Jan 1988
12
Olive Henrietta Goold
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.7.2]
b. 26 Sep 1903 d. 31 Jul 1935
12
Brigham Mon Victor Goold
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.7.3]
b. 29 Sep 1906 d. 6 Jan 1983
12
Herald Ensign Goold
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.7.4]
b. 28 Nov 1908 d. 31 Mar 1920
12
Helen Rozeltha Goold
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.7.5]
b. 10 Aug 1910 d. 18 Feb 1948
12
Esther La Rue Goold
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.7.6]
b. 15 Apr 1913 d. 7 Feb 1991
12
Living
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.7.7]
12
Living
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.7.8]
12
William George Goold
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.7.9]
b. 2 Dec 1918 d. 8 Nov 1995
11
Henrietta Persina Hill
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.8]
b. 16 Jul 1879 d. 11 Jun 1961
+
William Seth Parks
b. Abt 1875
11
Hulda Carinda Hill
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.9]
b. 19 Oct 1881 d. 24 Mar 1953
William Marade Norton
b. 20 Jan 1873 d. 27 May 1939
12
Vivian Hulda Norton
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.9.1]
b. 3 Jun 1902 d. 16 Feb 1938
12
Florence Alena Norton
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.9.2]
b. 21 Dec 1903 d. 26 Nov 1991
12
William Dewile Norton
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.9.3]
b. 21 Dec 1905 d. 22 Jun 1989
12
Preal Norton
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.9.4]
b. 11 Mar 1908 d. 17 Jan 1918
12
Elizabeth Norton
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.9.5]
b. 14 Apr 1910 d. 10 Jul 2005
12
Bardel Norton
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.9.6]
b. 16 Aug 1912 d. 7 Jun 1996
12
Loyal H Norton
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.9.7]
b. 18 Apr 1914 d. 6 Apr 1996
12
Eva Norton
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.9.8]
b. 7 Oct 1923 d. 28 Dec 1964
11
Betty Petty Hill
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.10]
b. 4 Sep 1884 d. 18 Jun 1917
Seamon Anthony Golding
b. 6 Dec 1878 d. 16 Nov 1955
12
Bettie Romania Golding
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.10.1]
b. 16 Oct 1904 d. 26 Jun 1963
12
Semon Rex Golding
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.10.2]
b. 8 Feb 1906 d. 6 Apr 1969
12
Vera Rebecca Golding
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.10.3]
b. 3 Mar 1908 d. 18 Jun 1981
12
Elden Barton Golding
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.10.4]
b. 16 Sep 1909 d. 4 Jan 1997
12
Nida Cloe Golding
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.10.5]
b. 15 Apr 1915 d. 25 Oct 2005
12
Son Golding
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.10.6]
b. 12 Jun 1917 d. 13 Jun 1917
11
William Strait Hill
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.11]
b. 23 Feb 1886 d. 2 Jan 1985
Fanny Hamblin
b. 13 May 1897 d. 7 Jun 1957
12
James Vernon Hill
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.11.1]
b. 7 Feb 1918 d. 21 Dec 1918
12
Cora Hill
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.11.2]
b. 30 Apr 1919 d. 11 Jun 1994
12
Fanny Lamar Hill
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.11.3]
b. 2 Dec 1920 d. 21 Jan 1995
12
William Norman Hill
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.11.4]
b. 9 Apr 1923 d. 12 Jan 1999
12
Shirley Rose Hill
[1.1.5.1.9.4.2.16.2.10.11.5]
b. 8 Jan 1927 d. 12 Oct 2001
+
Helena P Christensen
b. 11 Sep 1886 d. 15 Jun 1980
9
Nancy Alton
[1.1.5.1.9.4.2.16.3]
b. 8 Dec 1798
9
Orin Alton
[1.1.5.1.9.4.2.16.4]
b. 22 Oct 1801
9
Abel Alton
[1.1.5.1.9.4.2.16.5]
b. 16 Jun 1803 d. 19 Sep 1870
9
Irene Alton
[1.1.5.1.9.4.2.16.6]
b. 25 Apr 1807 d. 10 Aug 1852
7
Mary Sanger
[1.1.5.1.9.4.3]
b. 10 Aug 1717 d. 14 Mar 1741
7
Zerviah Sanger
[1.1.5.1.9.4.4]
b. 21 Dec 1718 d. 15 Apr 1812
7
Eliizabeth Sanger
[1.1.5.1.9.4.5]
b. Abt 1722 d. 14 Apr 1808
7
Narhanial Sanger
[1.1.5.1.9.4.6]
b. 24 Sep 1724 d. 12 Jul 1791
7
Irisah Sanger
[1.1.5.1.9.4.7]
b. 6 May 1727
7
Asa Sanger
[1.1.5.1.9.4.8]
b. 27 Aug 1736 d. 12 Jul 1791
7
Amasa Sanger
[1.1.5.1.9.4.9]
b. 12 Dec 1737 d. 22 Sep 1760
6
Bethia Morris Peake
[1.1.5.1.9.5]
b. 20 Feb 1698 d. 5 Aug 1779
6
Abigail Peake
[1.1.5.1.9.6]
b. 7 Apr 1700 d. 22 Feb 1776
6
Sarah Peake
[1.1.5.1.9.7]
b. 18 Apr 1702 d. 15 Mar 1801
John Morse
b. 29 Dec 1699 d. 13 Nov 1764
7
Deacon Jedidiah Morse
[1.1.5.1.9.7.1]
b. 8 Jul 1726 d. 29 Dec 1819
Sarah Child
b. Abt 1730 d. 5 Apr 1805
8
Jonathan Morse
[1.1.5.1.9.7.1.1]
b. 30 Apr 1750 d. 12 Jan 1835
8
Amos Morse
[1.1.5.1.9.7.1.2]
b. 1752 d. 15 Mar 1755
8
Calvin Morse
[1.1.5.1.9.7.1.3]
b. 30 Jun 1752 d. 7 Apr 1830
8
Sarah Morse
[1.1.5.1.9.7.1.4]
b. 1754 d. 5 Feb 1765
8
Dortha Morse
[1.1.5.1.9.7.1.5]
b. 29 Apr 1757 d. 23 Nov 1814
8
Lydia Morse
[1.1.5.1.9.7.1.6]
b. 22 Jun 1759 d. 9 Dec 1792
8
Jedidiah Morse
[1.1.5.1.9.7.1.7]
b. 23 Aug 1761 d. 9 Jun 1826
Elizabeth Ann Finley Breese
b. 9 Nov 1766 d. 28 May 1828
9
Samuel Finley Breese Morse
[1.1.5.1.9.7.1.7.1]
b. 27 Apr 1791 d. 2 Apr 1872
Lucretia Pickering Walker
b. 15 Jul 1799 d. 1825
10
Susan Morse
[1.1.5.1.9.7.1.7.1.1]
b. 2 Sep 1819 d. 5 Dec 1885
10
Charles Walker Morse
[1.1.5.1.9.7.1.7.1.2]
b. 15 May 1823 d. 16 Apr 1887
10
James Edward Finley Morse
[1.1.5.1.9.7.1.7.1.3]
b. 20 Jan 1825
Sarah Elizabeth Griswold
b. 25 Dec 1823 d. 14 Nov 1901
10
Samuel Arthur Breese Morse
[1.1.5.1.9.7.1.7.1.4]
b. 24 Jul 1849 d. 7 Jul 1876
10
Cornelia Livingston "Leila" Morse
[1.1.5.1.9.7.1.7.1.5]
b. 8 Apr 1851 d. 9 Dec 1937
10
William Goodrich Morse
[1.1.5.1.9.7.1.7.1.6]
b. 31 Jan 1853 d. 12 Jan 1933
10
Edward Lind Morse
[1.1.5.1.9.7.1.7.1.7]
b. Abt 1856 d. 1923
9
Jonathan Edwards Morse
[1.1.5.1.9.7.1.7.2]
b. 4 Oct 1792 d. 1795
9
Sidney Edwards Morse
[1.1.5.1.9.7.1.7.3]
b. 7 Feb 1794 d. 24 Dec 1871
9
Richard Cary Morse
[1.1.5.1.9.7.1.7.4]
b. 1795 d. 1868
9
Thomas Russell Morse
[1.1.5.1.9.7.1.7.5]
b. 6 May 1797 d. 1800
9
Elisabeth Ann Morse
[1.1.5.1.9.7.1.7.6]
b. 12 Jul 1798 d. 19 Jul 1799
9
James R. Morse
[1.1.5.1.9.7.1.7.7]
b. 26 Jan 1801 d. 13 Sep 1801
9
Elizabeth Ann Morse
[1.1.5.1.9.7.1.7.8]
b. 7 Jan 1803 d. 1806
9
Daughter Morse
[1.1.5.1.9.7.1.7.9]
b. 15 Mar 1805 d. 15 Mar 1805
9
Mary K Morse
[1.1.5.1.9.7.1.7.10]
b. 27 Jan 1807 d. 15 Jun 1807
9
Sarah K Morse
[1.1.5.1.9.7.1.7.11]
b. 14 Jun 1809 d. 22 Jan 1880
8
Leonard Morse
[1.1.5.1.9.7.1.8]
b. 11 Nov 1763 d. 16 Dec 1765
7
Priscilla Morse
[1.1.5.1.9.7.2]
b. 2 Feb 1729 d. 22 Dec 1760
7
Sarah Morse
[1.1.5.1.9.7.3]
b. 15 Jan 1731 d. 18 Dec 1795
7
Susannah Morse
[1.1.5.1.9.7.4]
b. 24 Aug 1734 d. 6 Nov 1802
7
Rebecca Morse
[1.1.5.1.9.7.5]
b. 5 Sep 1736 d. 15 May 1815
7
Lydia Morse
[1.1.5.1.9.7.6]
b. 27 Jul 1738 d. 29 Nov 1754
7
Hannah Morse
[1.1.5.1.9.7.7]
b. 1 Apr 1740
7
Mary Morse
[1.1.5.1.9.7.8]
b. 25 Dec 1742 d. 10 Nov 1754
7
Jonathan Morse
[1.1.5.1.9.7.9]
b. 20 Jan 1743 d. 1743
6
Katharine Peake
[1.1.5.1.9.8]
b. 29 Aug 1704 d. 15 Mar 1801
6
Jonathan Peake
[1.1.5.1.9.9]
b. Abt 1706 d. 23 Aug 1744
6
Ephraim Peake
[1.1.5.1.9.10]
b. 9 May 1709 d. Abt 1720
4
Dorcas Peake
[1.1.5.2]
b. 1 Mar 1640 d. 30 Dec 1697
4
Hannah Peake
[1.1.5.3]
b. 12 Jan 1642 d. 5 Oct 1660
4
Joseph Peake
[1.1.5.4]
b. 12 Feb 1644 d. 1688
+
Griffin Craft
b. 1610 d. 30 Dec 1697
3
Susan French
[1.1.6]
b. 22 Apr 1616 d. 25 Apr 1616
3
Anne French
[1.1.7]
b. 15 Mar 1617 bur. 16 Jun 1931
3
Margaret French
[1.1.8]
b. 12 Mar 1619 bur. 25 Nov 1635
Samuel Allen
b. 1596 d. 26 Aug 1671
4
Mary Allen
[1.1.8.1]
b. 1632
4
James Allen
[1.1.8.2]
b. 1636 d. 25 Jul 1714
4
Mary Allen
[1.1.8.3]
b. Abt 1642 d. 7 Apr 1712
3
Mary French
[1.1.9]
b. 6 Jan 1624 d. 1 Feb 1697
+
George Smith
b. 1620
2
Richard Riddlesdale
[1.2]
b. Abt 1586 d. 6 Nov 1610
2
Thomas Riddlesdale
[1.3]
b. 1588 d. Aft 1591
2
Dorcas Riddlesdale
[1.4]
b. 1590 d. 15 Dec 1610
2
Edward Riddlesdale
[1.5]
b. 1592 d. 9 Feb 1631
2
John Riddlesdale
[1.6]
b. 1594 d. 10 Dec 1602