Home Page
|
What's New
|
Photos
|
Histories
|
Headstones
|
Reports
|
Surnames
Search
First Name:
Last Name:
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Suomalainen
Svenska
John Gamon
Abt 1520 -
Submit Photo / Document
Individual
Descendants
Relationship
Timeline
Submit Photo / Doc
Worksheet
Family
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
John Gamon
[1]
b. Abt 1520
Mary Holmes
b. Abt 1524
2
Johan Gamon
[1.1]
b. Abt 1540 d. Abt 1569
Edmund Hankyns
b. 1535 d. 1569
3
Alice Hankin
[1.1.1]
b. Abt 1566 d. 1644
George A Ingersoll
b. Abt 1562 d. Abt 1644
4
Alice Ingersoll
[1.1.1.1]
b. 9 Jul 1585 d. 11 Nov 1590
4
Richard Ingersoll
[1.1.1.2]
c. 10 Mar 1587 bur. 2 Jan 1645
Agnes Ann Langley
b. 17 Mar 1576 d. 30 Jul 1677
5
John Ingersoll
[1.1.1.2.1]
b. 1 Oct 1615 d. 3 Sep 1684
5
Mary Ingersoll
[1.1.1.2.2]
b. 1621
5
Joanna Ingersoll
[1.1.1.2.3]
b. 3 Mar 1624 d. 1693
Richard Matthew Pettingell
b. 3 Mar 1625 d. 1681
6
Samuel Ingersoll Pettingell
[1.1.1.2.3.1]
b. 12 Sep 1644 d. 2 Jan 1711
Sarah Poore
b. 28 Dec 1652 d. 30 Jul 1735
7
Mary Farnham Pettingell
[1.1.1.2.3.1.1]
b. 13 Mar 1674 d. 1674
7
Samuel Pettingell
[1.1.1.2.3.1.2]
b. 3 Feb 1675 d. 24 Mar 1745
7
Richard Pettingell
[1.1.1.2.3.1.3]
b. 24 Jan 1679 d. 17 Aug 1761
7
Daniel Poore Pettingill
[1.1.1.2.3.1.4]
b. 16 Feb 1679 d. 12 May 1726
Mary Stickney
b. 9 Mar 1679 d. 7 Mar 1707
8
Ackerman Pettingill
[1.1.1.2.3.1.4.1]
b. 30 Jun 1700 d. 1770
Joanna Kingman
b. 7 May 1701 d. 1742
9
Nathan Pettingill
[1.1.1.2.3.1.4.1.1]
b. 28 May 1724
9
Daniel Pettingill
[1.1.1.2.3.1.4.1.2]
b. 10 Oct 1726 d. 20 Nov 1808
9
Hannah Pettingill
[1.1.1.2.3.1.4.1.3]
b. Abt 1728 d. 28 Jul 1799
David Soloman Avery
b. 22 Oct 1719 d. Sep 1791
10
Joanna Avery
[1.1.1.2.3.1.4.1.3.1]
b. 27 Jun 1747
10
Mehetable Avery
[1.1.1.2.3.1.4.1.3.2]
b. 20 Jun 1749
10
Thomas Avery
[1.1.1.2.3.1.4.1.3.3]
b. 3 Nov 1751
10
Dr Jonathan Avery
[1.1.1.2.3.1.4.1.3.4]
b. 8 Apr 1756 d. 1835
10
Jacob Avery
[1.1.1.2.3.1.4.1.3.5]
b. 9 Sep 1758
10
Ebenezer Avery
[1.1.1.2.3.1.4.1.3.6]
b. 13 Mar 1762 d. 10 Dec 1839
10
Polly Avery
[1.1.1.2.3.1.4.1.3.7]
b. 31 Mar 1763 d. 1828
Edmond Curtis
b. 27 Feb 1763 d. 17 Sep 1814
11
Enos Curtis
[1.1.1.2.3.1.4.1.3.7.1]
b. 9 Oct 1783 d. 1 Jun 1856
Ruth Franklin
b. 14 Nov 1790 d. 6 May 1848
12
Lydia Curtis
[1.1.1.2.3.1.4.1.3.7.1.1]
b. 5 Feb 1808 d. 5 Jul 1809
12
Maria Curtis
[1.1.1.2.3.1.4.1.3.7.1.2]
b. 22 Mar 1810 d. 5 May 1841
12
Martha Curtis
[1.1.1.2.3.1.4.1.3.7.1.3]
b. 12 Aug 1812 d. 22 Dec 1834
12
Edmond Curtis
[1.1.1.2.3.1.4.1.3.7.1.4]
b. 5 Nov 1814 d. 6 Jan 1815
12
Jeremiah Curtis
[1.1.1.2.3.1.4.1.3.7.1.5]
b. 12 Nov 1815 d. 22 Feb 1816
12
Seth Curtis
[1.1.1.2.3.1.4.1.3.7.1.6]
b. 8 Mar 1817 d. 8 Mar 1817
12
Simmons Philander Curtis
[1.1.1.2.3.1.4.1.3.7.1.7]
b. 26 Mar 1818 d. 11 Apr 1880
12
David Avery Curtis
[1.1.1.2.3.1.4.1.3.7.1.8]
b. 10 Aug 1820 d. 5 Oct 1885
12
John White Curtis
[1.1.1.2.3.1.4.1.3.7.1.9]
b. 11 Aug 1820 d. 7 Oct 1902
12
Ezra Houghton Curtis
[1.1.1.2.3.1.4.1.3.7.1.10]
b. 19 Feb 1823 d. 28 Aug 1915 [
=>
]
12
Ruth Curtis
[1.1.1.2.3.1.4.1.3.7.1.11]
b. 4 Jun 1825 d. 4 Oct 1825
12
Ursula Curtis
[1.1.1.2.3.1.4.1.3.7.1.12]
b. 14 Dec 1826 d. 20 Jun 1902
12
Sabrina Curtis
[1.1.1.2.3.1.4.1.3.7.1.13]
b. 3 Apr 1829 d. 27 Jun 1890 [
=>
]
12
Celestia Curtis
[1.1.1.2.3.1.4.1.3.7.1.14]
b. 21 Apr 1832 d. 17 Jun 1891
11
Clarissa Curtis
[1.1.1.2.3.1.4.1.3.7.2]
b. 1788 d. 8 Nov 1844
Peleg Ewell
b. 2 Mar 1782 d. 1866
12
Philander Ewell
[1.1.1.2.3.1.4.1.3.7.2.1]
b. 3 Mar 1809 d. 17 Aug 1895
12
Thomas J Ewell
[1.1.1.2.3.1.4.1.3.7.2.2]
b. 23 Oct 1810 d. Sep 1876
12
Lebeus Ewell
[1.1.1.2.3.1.4.1.3.7.2.3]
b. 12 Sep 1812
12
Avelina Ewell
[1.1.1.2.3.1.4.1.3.7.2.4]
b. 1 Jan 1815 d. 10 Dec 1843
12
Edmond Cole Ewell
[1.1.1.2.3.1.4.1.3.7.2.5]
b. 7 May 1817 d. 20 Oct 1907
12
Marian Ewell
[1.1.1.2.3.1.4.1.3.7.2.6]
b. 10 Oct 1819 d. 6 Feb 1827
12
Irena Ewell
[1.1.1.2.3.1.4.1.3.7.2.7]
b. 17 Dec 1821 d. 20 Aug 1906
12
Peleg Dilloway F Ewell
[1.1.1.2.3.1.4.1.3.7.2.8]
b. 28 Mar 1824 d. 27 Dec 1887
12
Mabel Ewell
[1.1.1.2.3.1.4.1.3.7.2.9]
b. 8 May 1826 d. 23 Nov 1893
12
Luther J Ewell
[1.1.1.2.3.1.4.1.3.7.2.10]
b. 5 Oct 1828 d. 11 Aug 1898
12
Clarissa A Ewell
[1.1.1.2.3.1.4.1.3.7.2.11]
b. 30 Mar 1831 d. 9 Jul 1899
12
Sarah Ewell
[1.1.1.2.3.1.4.1.3.7.2.12]
b. Abt 1833
9
Mathew Pettingill
[1.1.1.2.3.1.4.1.4]
b. 1732
9
Jacob Pettingill
[1.1.1.2.3.1.4.1.5]
b. 1734 d. Aft 1780
9
Stephen Pettingill
[1.1.1.2.3.1.4.1.6]
b. Abt 1740 d. Aft 1790
9
Silence Pettingill
[1.1.1.2.3.1.4.1.7]
b. 9 Feb 1744
8
Daniel Pettingill
[1.1.1.2.3.1.4.2]
b. 5 Jan 1704 d. Abt 15 Jun 1755
8
Mehitable Pettingill
[1.1.1.2.3.1.4.3]
b. 1706 d. 1743
8
Samuel Pettingill
[1.1.1.2.3.1.4.4]
b. 6 Mar 1708 d. Bef 31 May 1780
8
Obadiah Pettingill
[1.1.1.2.3.1.4.5]
b. Abt 1710 d. 18 Oct 1743
8
Esther Pettingell
[1.1.1.2.3.1.4.6]
b. 24 Oct 1712 d. 19 Jul 1735
7
John Pettingell
[1.1.1.2.3.1.5]
b. 20 Sep 1680 d. 22 May 1742
7
Thomas Pettingell
[1.1.1.2.3.1.6]
b. 12 Nov 1682 d. Abt 1752
7
Joseph Pettingell
[1.1.1.2.3.1.7]
b. 27 Nov 1684 d. Aft 1716
7
Mary Pettingell
[1.1.1.2.3.1.8]
b. 20 Jan 1685
7
Sarah Pettingell
[1.1.1.2.3.1.9]
b. 20 Jan 1685 d. Abt 1755
7
Joanna Pettingell
[1.1.1.2.3.1.10]
b. 10 Feb 1688
6
Matthew Pettingell
[1.1.1.2.3.2]
b. 18 Nov 1648 d. 20 Jul 1714
6
Mary Pettingell
[1.1.1.2.3.3]
b. 6 Jul 1652 d. 19 Sep 1705
6
John Pettingell
[1.1.1.2.3.4]
b. 21 Sep 1654 d. 11 Feb 1717
6
Robert Pettingell
[1.1.1.2.3.5]
b. 15 Nov 1657 d. 17 Nov 1657
6
Henry Pettingell
[1.1.1.2.3.6]
b. 16 Jan 1659 d. 20 Jan 1659
5
Sarah Ingersoll
[1.1.1.2.4]
b. Abt 1 Jul 1627 d. Abt 1719
5
Bathsheba Ingersoll
[1.1.1.2.5]
b. 1 Jul 1629 d. 24 Oct 1705
5
Deacon Nathaniel Ingersoll
[1.1.1.2.6]
b. 1632 d. 27 Jan 1719
Hannah Collins
b. Abt 21 Oct 1632 d. 8 Feb 1682
6
Daughter Ingersoll
[1.1.1.2.6.1]
b. Abt 1658
6
Nathaniel Ingersoll
[1.1.1.2.6.2]
b. 1660 d. 1683
6
Sarah Ingersoll
[1.1.1.2.6.3]
b. 1663 d. 13 Oct 1732
James Emerson
b. Abt 1660 d. Abt 1756
7
Elizabeth Emerson
[1.1.1.2.6.3.1]
b. 6 Mar 1686 d. 18 Jun 1747
Captain Joseph Taft
b. 1680 d. 18 Jun 1747
8
Lucy Taft
[1.1.1.2.6.3.1.1]
b. 22 Sep 1709
8
Lieutenant Moses Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2]
b. 30 Jan 1712 d. 16 Jul 1778
Priscilla Thayer
b. 6 Jun 1717 d. Aft 1761
9
Lieutenant Abner Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.1]
b. 28 Dec 1736 d. 30 May 1809
Tryal White
b. 8 May 1737 d. 14 Jun 1814
10
Oliver Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.1.1]
b. 1 May 1758 d. 16 Jul 1775
10
Moses Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.1.2]
b. 29 Sep 1760 d. 4 Dec 1848
Judith Cummings
b. 26 Nov 1766 d. 26 Nov 1816
11
Nancy Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.1.2.1]
b. 10 Mar 1787
11
Samuel Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.1.2.2]
b. 24 Sep 1790 d. 11 Oct 1863
11
Lucy Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.1.2.3]
b. 24 Apr 1795 d. 21 Jun 1847
11
Newell Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.1.2.4]
b. 28 Jul 1804 d. 4 Nov 1873
Hannah G Taft
b. 18 May 1802 d. 8 Jan 1843
12
Albert Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.1.2.4.1]
b. 28 Aug 1823 d. Aft 1874 [
=>
]
12
Marcy Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.1.2.4.2]
b. Mar 1829 d. 12 Apr 1830
12
Charles M Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.1.2.4.3]
b. Jan 1843 d. 7 Dec 1843
11
Sylvia Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.1.2.5]
b. 23 Aug 1810 d. 3 Aug 1816
10
Mary Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.1.3]
b. 12 Oct 1767 d. 18 Aug 1775
10
Webb Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.1.4]
b. 26 Mar 1772 d. 21 Apr 1842
Lucy Taft
b. 9 Jun 1774 d. 14 Mar 1846
11
Lucinda Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.1.4.1]
b. 22 Nov 1793
11
Jason Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.1.4.2]
b. 5 Jun 1796 d. 25 Oct 1861
10
Trial T Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.1.5]
b. 13 Apr 1777 d. 18 Aug 1815
9
James Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.2]
b. 9 Apr 1738 d. 14 Jan 1826
Esther Taft
b. 9 Jan 1747 d. 3 Feb 1834
10
Lucy Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.1]
b. 22 Nov 1769 d. 29 Jul 1845
Ebenezer Winslow
b. 21 Jan 1772 d. 21 Feb 1841
11
Albert Winslow
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.1.1]
b. 24 Jul 1797
Sarah Gardner
b. 25 Jul 1803 d. 23 Sep 1840
12
Martha Maria Winslow
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.1.1.1]
b. 12 Mar 1826 d. 16 Mar 1842
12
Preston Willard Winslow
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.1.1.2]
b. 13 Nov 1828 [
=>
]
12
Mary Augusta Allen Winslow
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.1.1.3]
b. 14 Sep 1831
12
John Alvin Winslow
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.1.1.4]
b. 3 Jul 1834
12
Jasper Ross Winslow
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.1.1.5]
b. 7 Apr 1837 d. 25 Oct 1841
12
Sarah Adaline Winslow
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.1.1.6]
b. 20 Dec 1839 d. 9 Dec 1841
Sylvia Babbit
b. 27 Jan 1814
12
Jasper Albert Winslow
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.1.1.7]
b. 15 Apr 1842 d. 14 Oct 1864
11
Claramond Winslow
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.1.2]
b. 10 Feb 1799 d. 27 Apr 1834
John Hathaway
b. 22 May 1797
12
Son Hathaway
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.1.2.1]
b. Apr 1828 d. 14 Apr 1828
12
Francis Ebenezer Hathaway
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.1.2.2]
b. 9 Mar 1829 [
=>
]
12
Catherine Elizabeth Hathaway
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.1.2.3]
b. 18 Feb 1833
12
George H Hathaway
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.1.2.4]
b. 13 Aug 1839 [
=>
]
11
Alvin Winslow
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.1.3]
b. 27 Aug 1802 d. 9 Oct 1803
11
Paulina Maria Winslow
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.1.4]
b. 27 May 1805
+
Austin Crosby
b. 10 Mar 1805 d. 13 Jun 1868
11
Lucy Emma Winslow
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.1.5]
b. 17 Feb 1808 d. 20 Feb 1870
+
Matthew Henry McClary
b. 10 Mar 1801
10
Zilpha Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.2]
b. 1 Jul 1772 d. 24 Feb 1848
Nathan Fisher
b. 25 Jun 1770 d. 21 Mar 1847
11
Elias Fisher
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.2.1]
b. 10 Jul 1796
11
Elise Fisher
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.2.2]
b. 10 Jul 1796
11
Josiah Fisher
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.2.3]
b. 26 Feb 1798 d. 11 Apr 1799
11
Josiah Fisher
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.2.4]
b. 1 Dec 1801
11
Rachel Adaline Fisher
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.2.5]
b. 29 Jan 1804
+
Moses Daniels Southwick
11
Mary Caroline Fisher
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.2.6]
b. 22 Mar 1806
11
Nathan Fisher
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.2.7]
b. 21 Mar 1811
10
Irena Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.3]
b. 25 Oct 1774 d. 29 May 1790
10
Ezekial Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.4]
b. 21 Jan 1777 d. 24 Apr 1841
+
Olive Thayer
b. 10 Aug 1782 d. 1865
10
James Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.5]
b. 13 Jun 1780
10
Luke Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.6]
b. 3 Jun 1783
Nancy Wood
b. 6 Feb 1787 d. 6 May 1859
11
Clarissa Wood Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.6.1]
b. 3 May 1810 d. 1889
Caleb Chapin
b. 6 Feb 1806 d. 27 Sep 1883
12
Eunice Chapin
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.6.1.1]
b. 1 May 1832 d. 29 Sep 1920 [
=>
]
12
Ezra Wood Chapin
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.6.1.2]
b. 7 Jun 1836 d. 31 Mar 1909 [
=>
]
12
Edwin Chapin
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.6.1.3]
b. 7 Jun 1836 d. 27 Sep 1836
11
Moses Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.6.2]
b. 26 Jan 1812
Sylvia Ann Wheelock
b. 3 Feb 1815 d. 3 Oct 1855
12
Sarah Wood Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.6.2.1]
b. 6 Jan 1838 [
=>
]
12
Susan Hortense Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.6.2.2]
b. 5 Jan 1843
12
Luke Herbert Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.6.2.3]
b. 9 Nov 1846
11
Sarah Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.6.3]
b. 15 Jan 1815 d. 24 Dec 1898
Amariah Albee Wood
b. 2 Nov 1802 d. 14 Jun 1871
12
Sarah A Wood
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.6.3.1]
b. May 1837 d. 26 Sep 1837
12
Samuel Taft Wood
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.6.3.2]
b. 4 Oct 1841 d. Jun 1925 [
=>
]
12
Mary Baylies Wood
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.6.3.3]
b. 29 Apr 1847 d. 9 Sep 1847
12
Anna I Wood
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.6.3.4]
b. 18 Aug 1848 d. 1919
11
Irene Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.6.4]
b. 19 Sep 1816 d. 26 Jan 1900
Silas Mandeville Wheelock
b. 11 Nov 1817 d. 18 Oct 1901
12
Ellen Maria Wheelock
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.6.4.1]
b. 2 Sep 1842 d. 1871
12
Eugene Augustus Wheelock
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.6.4.2]
b. 15 Feb 1846 d. 14 Sep 1912 [
=>
]
12
Alice Augusta Wheelock
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.6.4.3]
b. 22 Jan 1849 d. Sep 1891
12
Arthur Wheelock
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.6.4.4]
b. 26 Mar 1851 d. 23 Sep 1927 [
=>
]
12
Henry Wheelock
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.6.4.5]
b. 14 Jan 1857 d. 13 Nov 1881
11
Chloe M Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.6.5]
b. 5 Feb 1823
Luke Southwick Farnham
b. 20 Jan 1817 d. 23 Aug 1883
12
Elizabeth Southwick Farnham
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.6.5.1]
b. 1852
12
Ella Frances Farnham
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.6.5.2]
b. 1855
12
Moses Taft Farnham
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.6.5.3]
b. 1858
12
Walter James Farnham
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.6.5.4]
b. 1862
11
James Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.6.6]
b. 1830
10
Esther Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.7]
b. 5 Aug 1786 d. 10 Aug 1858
Fuller Murdock
b. 17 Feb 1781 d. 8 Nov 1857
11
Philena Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.7.1]
b. 26 Aug 1807 d. 30 Jun 1835
Samuel Merriam
b. Abt 1803
12
George Nison Merriam
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.7.1.1]
b. 26 Dec 1834 d. 19 Nov 1903 [
=>
]
11
Abba Eliza Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.7.2]
b. 13 Nov 1808 d. 4 Apr 1834
Pemberton Brown
b. 11 Oct 1801 d. 30 Mar 1870
12
Tarissa Gregory Brown
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.7.2.1]
b. 3 Oct 1828 d. 12 Oct 1914 [
=>
]
12
Josephine Brown
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.7.2.2]
b. 29 Jan 1830 d. 16 Jan 1895 [
=>
]
12
Adin Ballou Brown
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.7.2.3]
b. 14 Nov 1831 d. 19 Apr 1880
12
Edin Ballow Brown
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.7.2.4]
b. 14 Nov 1831
12
Abba Eliza Brown
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.7.2.5]
b. 30 Jun 1833 d. 19 Oct 1914 [
=>
]
11
Moses Taft Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.7.3]
b. 12 Sep 1810 d. 7 Feb 1883
Dorinda Wood Grout
b. 19 Aug 1810 d. 15 Jan 1888
12
Cyrus Grout Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.7.3.1]
b. 16 Jun 1833 d. 7 Jun 1913 [
=>
]
12
Lewis Henry Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.7.3.2]
b. 17 Mar 1835 d. 25 Mar 1916 [
=>
]
12
Sarah A Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.7.3.3]
b. Jul 1837 d. 1 Sep 1838
12
Lucius Walter Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.7.3.4]
b. 11 Apr 1846 d. 1 Jul 1867
12
Samuel Justin Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.7.3.5]
b. 13 May 1848 d. 11 May 1910 [
=>
]
12
Lyman Wood Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.7.3.6]
b. 26 Dec 1853 d. Bef 1900 [
=>
]
11
John Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.7.4]
b. 9 Sep 1812 d. 13 Sep 1837
11
Charles Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.7.5]
b. 11 Feb 1815 d. 6 Aug 1869
Mary Ann Weightman
b. 3 Apr 1823 d. 11 May 1895
12
Charles W Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.7.5.1]
b. 4 Mar 1854 d. 5 Mar 1916 [
=>
]
11
Caleb Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.7.6]
b. 16 Feb 1817 d. 10 May 1892
Maria Howard Emerson
b. 27 Dec 1830 d. 11 Oct 1901
12
Frank Fuller Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.7.6.1]
b. 18 May 1857 d. 13 Jan 1939 [
=>
]
12
Herbert Emerson Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.7.6.2]
b. 16 Jan 1859 d. 18 Jan 1931 [
=>
]
12
Eugene Clifford Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.7.6.3]
b. 24 Nov 1863 d. 13 Sep 1924
12
Carrie Maria Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.7.6.4]
b. 4 Sep 1865 [
=>
]
11
George Taft Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.7.7]
b. 18 Mar 1819
Abbie Ann Robinson
b. Abt 1825
12
George Thurston Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.7.7.1]
b. 4 Jul 1846 d. 30 Jan 1933 [
=>
]
12
Lizzie Green Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.7.7.2]
b. 2 Sep 1857 d. 3 May 1879 [
=>
]
11
Harriet E. Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.7.8]
b. 6 Feb 1821 d. 30 Nov 1904
David Franum Wood
b. 16 Feb 1818 d. 4 Feb 1896
12
Arthur Eugene Wood
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.7.8.1]
b. 20 Jan 1844 d. 20 Apr 1920 [
=>
]
12
Hattie Esther Wood
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.7.8.2]
b. 5 Aug 1855 [
=>
]
11
Chapin Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.7.9]
b. 20 Jun 1823 d. 17 Sep 1882
Julia A Smith
b. 1824 d. 21 Jun 1909
12
Luther Oscar Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.7.9.1]
b. 6 Oct 1848 d. 1 Nov 1904 [
=>
]
12
Loren Nelson Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.7.9.2]
b. 3 Jul 1850 d. 11 May 1923 [
=>
]
12
Eldoras Filasker Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.7.9.3]
b. 18 Jun 1852 [
=>
]
12
William Fuller Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.7.9.4]
b. 19 Jun 1855 d. 26 Nov 1924 [
=>
]
12
Emma E Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.7.9.5]
b. 30 May 1857 d. 23 Jul 1913 [
=>
]
11
Mary Ann Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.7.10]
b. 18 Jun 1825 d. 27 Aug 1834
10
Moses Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.8]
b. 14 Jul 1788 d. 26 Jun 1810
10
Abigail Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.9]
b. 24 Jan 1791 d. 15 May 1837
Chandler Taft
b. 29 May 1792
11
Augustine Calvin Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.9.1]
b. 11 May 1817
Deborah Millett Taylor
12
Alice Bradford Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.9.1.1]
b. 26 Oct 1841
12
Edward A Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.2.9.1.2]
b. 8 Apr 1845
9
Ruth Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.3]
b. 19 Feb 1740 d. 27 Jun 1797
9
Moses Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.4]
b. 21 Dec 1742
9
Margaret Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.5]
b. 19 Feb 1743 d. 3 Oct 1761
9
Nahum Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.6]
b. 17 Aug 1745
9
Priscilla Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.7]
b. 30 Apr 1749 d. 12 Sep 1833
Timothy Taft
b. 3 Apr 1750 d. 30 Nov 1808
10
Marcy Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.7.1]
b. 28 Sep 1771 d. 1 Aug 1848
+
Ezekiah Preston
b. Abt 1771
10
Josiah Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.7.2]
b. 3 May 1774
10
Abigail Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.7.3]
b. 14 Jan 1777 d. 17 Dec 1832
Moses Stone
b. 2 Mar 1775 d. 10 May 1803
11
Jonas Stone
[1.1.1.2.6.3.1.2.7.3.1]
b. 6 Jun 1795 d. 30 Sep 1795
11
Sukey Stone
[1.1.1.2.6.3.1.2.7.3.2]
b. 19 Feb 1798
10
Polly Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.7.4]
b. 1779 d. 5 Sep 1785
10
Timothy Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.7.5]
b. 1782 d. 5 Jan 1818
Mary "Polly" Reidel
b. 8 Feb 1784 d. 8 Feb 1863
11
Timothy Clark Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.7.5.1]
b. 21 Jul 1800 d. 11 May 1872
Mary A Hitchcock
b. 4 Jan 1802 d. 26 Oct 1842
12
Samuel Adams Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.7.5.1.1]
b. 11 Mar 1830 d. 5 Feb 1916 [
=>
]
12
Elizabeth C Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.7.5.1.2]
b. 6 Jun 1834 d. 13 Dec 1915 [
=>
]
11
Adolphus Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.7.5.2]
b. Abt 1804
11
Harry Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.7.5.3]
b. Abt 1806
11
Ezekiel Preston Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.7.5.4]
b. Abt 1807
11
Washington Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.7.5.5]
b. Abt 1808 d. Abt 1823
11
Charlotte Clark Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.7.5.6]
b. Abt 1810
+
Hyman Sage
b. Abt 1810
11
Christine Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.7.5.7]
b. 1811 d. 8 Jul 1847
+
George Heath
b. Abt 1811
11
Jacob R Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.7.5.8]
b. 29 Oct 1814 d. 1 Jan 1875
+
Caroline Cowles
b. 10 Jun 1817 d. 25 Jun 1875
10
Joseph Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.7.6]
b. 1784
10
Jonas Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.7.7]
b. 1786
10
Polly Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.7.8]
b. 1788 d. 1859
9
Joseph Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.8]
b. 6 Jul 1751 d. 2 Jul 1828
Hannah Keith
b. 17 Jul 1753 d. 2 Apr 1842
10
Oliver Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.8.1]
b. 6 Nov 1771 d. 20 Feb 1853
Chloe
b. 1782 d. 24 Nov 1841
11
Olive Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.8.1.1]
b. 1 Mar 1806 d. 27 Jan 1867
11
Amariah Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.8.1.2]
b. 19 Sep 1807 d. 28 Aug 1873
Mary Richards
b. Abt 1819 d. 22 Apr 1875
12
Ophelia Adams Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.8.1.2.1]
b. 23 Jan 1841 [
=>
]
12
Mary Elizabeth Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.8.1.2.2]
b. 23 May 1843 d. 8 Apr 1845
12
Francis Amariel Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.8.1.2.3]
b. 18 Sep 1847 d. 28 Jul 1848
11
Oliver Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.8.1.3]
b. 16 Jun 1812 d. 25 Mar 1876
Sarah Richardson
b. 1821
12
Horace H Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.8.1.3.1]
b. 1846 d. 11 May 1863
12
Jennis Isadora Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.8.1.3.2]
b. 12 Apr 1857 d. 21 Aug 1863
11
Maryan Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.8.1.4]
b. 9 Jul 1814
Hosea Aldrich
b. 14 Mar 1803
12
Chloe M Aldrich
[1.1.1.2.6.3.1.2.8.1.4.1]
b. 17 Jan 1838
12
Watee E Aldrich
[1.1.1.2.6.3.1.2.8.1.4.2]
b. 1 Sep 1840
12
Sylvia Ann Aldrich
[1.1.1.2.6.3.1.2.8.1.4.3]
b. 20 Jul 1844
11
George Washington Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.8.1.5]
b. 13 May 1823
Laura Ann M Taft
b. 26 Jun 1824 d. 26 May 1855
11
Laura Ann Maria Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.8.1.6]
b. 7 Jul 1844
11
Son Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.8.1.7]
b. 7 Jul 1844 d. 21 Jul 1844
11
Joseph K Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.8.1.8]
b. 25 Sep 1846 d. Jul 1868
11
Chloe Jane Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.8.1.9]
b. 25 Nov 1849
10
Huldah Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.8.2]
b. 17 Feb 1775 d. Bef 21 May 1780
10
Huldah Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.8.3]
b. 21 May 1780 d. 11 Oct 1811
Parker Tyler
b. 14 Nov 1790 d. 28 Jun 1853
11
Huldah Tyler
[1.1.1.2.6.3.1.2.8.3.1]
b. 4 Oct 1811
Matthew Borland
b. Abt 1800
12
Huldah J Borland
[1.1.1.2.6.3.1.2.8.3.1.1]
b. 28 Sep 1831 d. 10 Nov 1907 [
=>
]
12
Margaret Borland
[1.1.1.2.6.3.1.2.8.3.1.2]
b. 13 Apr 1836 d. 21 Oct 1882 [
=>
]
12
Samuel Borland
[1.1.1.2.6.3.1.2.8.3.1.3]
b. Abt 1841
12
John P Borland
[1.1.1.2.6.3.1.2.8.3.1.4]
b. Abt 1849
11
Hannah Tyler
[1.1.1.2.6.3.1.2.8.3.2]
b. 4 Oct 1811 d. 18 Oct 1811
11
Martha Almira Tyler
[1.1.1.2.6.3.1.2.8.3.3]
b. 28 Sep 1830 d. 16 Oct 1909
William S Jones
b. 26 Sep 1827 d. 26 Sep 1907
12
Anna Almira Jones
[1.1.1.2.6.3.1.2.8.3.3.1]
b. 16 Jun 1850 d. 2 May 1922 [
=>
]
12
Wilber Jones
[1.1.1.2.6.3.1.2.8.3.3.2]
b. 1852
12
Albert J Jones
[1.1.1.2.6.3.1.2.8.3.3.3]
b. 10 Jun 1857 d. 17 Jun 1937 [
=>
]
12
Eva Jones
[1.1.1.2.6.3.1.2.8.3.3.4]
b. 29 May 1861 d. 13 Aug 1924
12
Wilbur Sherman Jones
[1.1.1.2.6.3.1.2.8.3.3.5]
b. 17 Oct 1865 d. 1942
10
Hannah Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.8.4]
b. 29 Sep 1783
10
Peter Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.8.5]
b. 24 Apr 1786
9
Luke Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.9]
b. 10 Aug 1754
9
Joanna Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.10]
b. 26 Jun 1756 d. 30 Sep 1761
9
Josiah Taft
[1.1.1.2.6.3.1.2.11]
b. 1 Oct 1758 d. 29 Sep 1761
8
Peter Rawson Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3]
b. 1715 d. 12 Dec 1783
Elizabeth Cheney
b. 21 Sep 1707 d. 21 Sep 1783
9
Henry Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.1]
b. 7 Feb 1737 d. 2 Feb 1812
Sarah Howe
b. 14 Apr 1742 d. 26 Jun 1789
10
Joel Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.1.1]
b. 7 Nov 1763 d. 10 Oct 1855
Polly Earle
b. 28 Mar 1774 d. 1864
11
Martha Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.1.1.1]
b. 24 Dec 1802 d. Bef 1860
11
Emons Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.1.1.2]
b. 7 Apr 1804
11
Lewis Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.1.1.3]
b. 1814 d. Bef 1860
Mary Ann Stone
b. 22 Mar 1818 d. 27 Feb 1899
12
Fayette L Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.1.1.3.1]
b. Abt 1843
12
Hannah Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.1.1.3.2]
b. Abt 1845
11
Rufus Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.1.1.4]
b. 18 Mar 1817 d. Bef 1860
11
Roxana Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.1.1.5]
b. 14 Dec 1819 d. Bef 1860
10
Peter Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.1.2]
b. 11 Jan 1773
Phebe Wheaton
b. 28 May 1771
11
Phebe Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.1.2.1]
b. 15 Jan 1809 d. 12 Mar 1849
Cyrus Hodges
b. 1 Apr 1803 d. 1 Mar 1873
12
Adonijah White Hodges
[1.1.1.2.6.3.1.3.1.2.1.1]
b. 9 Aug 1827 d. 18 Apr 1828
12
Henry Francisco Hodges
[1.1.1.2.6.3.1.3.1.2.1.2]
b. 20 Oct 1828
12
Harry Sylvanies Hodges
[1.1.1.2.6.3.1.3.1.2.1.3]
b. 20 Oct 1828 d. 20 Nov 1828
12
Seth Blowers Hodges
[1.1.1.2.6.3.1.3.1.2.1.4]
b. 18 Mar 1831 d. 20 May 1907 [
=>
]
12
George Luther Hodges
[1.1.1.2.6.3.1.3.1.2.1.5]
b. 6 Aug 1833 d. 14 Sep 1833
12
Orlin Chapman Hodges
[1.1.1.2.6.3.1.3.1.2.1.6]
b. 28 Aug 1835 d. 19 May 1836
12
Amos Van Buren Hodges
[1.1.1.2.6.3.1.3.1.2.1.7]
b. 25 Apr 1838 d. 1 Nov 1849
12
Phebe Alice Hodges
[1.1.1.2.6.3.1.3.1.2.1.8]
b. 2 Oct 1840 d. 11 Nov 1849
12
Sarah Salina Hodges
[1.1.1.2.6.3.1.3.1.2.1.9]
b. 14 Dec 1842 d. 18 Nov 1849
12
June Hodges
[1.1.1.2.6.3.1.3.1.2.1.10]
b. 7 Jul 1846 d. 15 Jul 1846
12
John Hodges
[1.1.1.2.6.3.1.3.1.2.1.11]
b. 7 Jul 1846 d. 19 Jul 1846
10
Lydia Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.1.3]
b. 15 Oct 1766 d. 28 Jul 1786
10
Amos Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.1.4]
b. 26 Aug 1768 d. 6 Aug 1789
10
Sarah Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.1.5]
b. 18 Jan 1771 d. 22 Feb 1792
10
Caleb Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.1.6]
b. 2 Apr 1775 d. 26 Oct 1840
Lois Carleton
b. Abt 1776
11
Lois Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.1.6.1]
b. 10 Mar 1801
11
Rhoda Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.1.6.2]
b. 20 Oct 1802
11
Calvin Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.1.6.3]
b. 11 Dec 1804
11
Lydia Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.1.6.4]
b. 30 Apr 1806
11
Nancy Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.1.6.5]
b. 19 Sep 1809
11
Dudley Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.1.6.6]
b. 6 Nov 1811
Calista Anne Dodge
b. 14 Nov 1817
12
George Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.1.6.6.1]
b. Abt 1841
12
Helen Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.1.6.6.2]
b. Abt 1844
12
Elbridge Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.1.6.6.3]
b. Abt 1847 [
=>
]
12
John E. Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.1.6.6.4]
b. Abt 1849
12
Henry Edgar Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.1.6.6.5]
b. 12 Apr 1856 d. 7 Sep 1927 [
=>
]
11
Daniel Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.1.6.7]
b. 21 Dec 1815
10
Abisha Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.1.7]
b. 15 Jun 1777
Mary Bliss
d. 1 Feb 1822
11
Tryphina Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.1.7.1]
b. 29 Jun 1810 d. 13 Oct 1849
11
Clarissa Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.1.7.2]
b. 1817 d. 24 Dec 1840
11
Denison Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.1.7.3]
b. 6 Jun 1819
Louisa Mary Gale
b. 5 Oct 1818 d. 15 Jun 1853
12
John A Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.1.7.3.1]
b. 8 Jul 1845
12
Clara L Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.1.7.3.2]
b. 24 Feb 1847 d. Jan 1867
12
Lucius D Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.1.7.3.3]
b. 1 Dec 1852
+
Sally Sprague
10
David Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.1.8]
b. 13 Aug 1779
9
Gershom Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.2]
b. 20 Oct 1739 d. 29 Apr 1813
Abigail Reed
b. 12 Dec 1736 d. 24 Feb 1816
10
Calvin Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.2.1]
b. 17 Nov 1765 d. 12 Feb 1816
Molley
b. 1755 d. 12 Feb 1847
11
Newell Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.2.1.1]
b. 13 Feb 1788
11
Benjamin Clark Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.2.1.2]
b. 17 May 1790
11
Chandler Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.2.1.3]
b. 29 May 1792
Abigail Taft
b. 24 Jan 1791 d. 15 May 1837
12
Augustine Calvin Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.2.1.3.1]
b. 11 May 1817 [
=>
]
11
Ohila Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.2.1.4]
b. 25 Mar 1796
11
Mellen Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.2.1.5]
b. 18 Oct 1799 d. 3 Jun 1839
11
Mary Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.2.1.6]
b. 25 Aug 1803 d. 20 Feb 1816
11
Eliza Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.2.1.7]
b. 20 Jun 1805
11
James Whitman Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.2.1.8]
b. 21 Jan 1809 d. 8 Aug 1834
10
Elisabeth Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.2.2]
b. 13 May 1769 d. Bef 1871
10
Cheney Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.2.3]
b. 3 May 1771 d. 27 Jun 1838
10
Ruth Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.2.4]
b. 23 Feb 1773
10
Phila Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.2.5]
b. 4 Jul 1775 d. 29 Sep 1776
10
Reed Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.2.6]
b. 13 Mar 1780
9
Peter Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.3]
b. 26 Aug 1741 d. 13 Sep 1802
+
Mercy Corpe
b. 11 Dec 1732
9
Aaron Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.4]
b. 28 May 1743 d. 26 Mar 1808
Rhoda Rawson
b. 4 Oct 1749 d. 9 Jun 1827
10
Millie Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.1]
b. 29 Jul 1769
Ezekiel Clark
b. 13 Apr 1766
11
Willard Boyd Clark
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.1.1]
b. 18 May 1792
11
William B Clark
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.1.2]
b. 15 Apr 1793 d. 27 Apr 1818
11
Lucis Clark
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.1.3]
b. 4 Sep 1795
11
Lewis C Clark
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.1.4]
b. 6 Sep 1795 d. 16 Jan 1831
11
Maria Clark
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.1.5]
b. 12 Jul 1798
+
Jacob Bryant
11
Franklin Clark
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.1.6]
b. 13 Dec 1801 d. 1 Feb 1846
11
Charles T Clark
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.1.7]
b. 8 Apr 1804
10
Selina Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.2]
b. 20 Feb 1771 d. 22 Sep 1838
Jesse Ensign Murdock
b. 13 Sep 1762 d. 11 May 1850
11
Judson Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.2.1]
b. 24 Aug 1794 d. 26 Jun 1877
Judith Brigham Murdock
b. 10 Oct 1797 d. 8 Jun 1881
12
Cornelia Maria Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.2.1.1]
b. 17 Dec 1817 d. 14 Dec 1882 [
=>
]
12
Ann L Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.2.1.2]
b. 1819 d. Dec 1819
12
Louise Jane Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.2.1.3]
b. 23 Jun 1823 d. 6 Jun 1841
12
Candace J Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.2.1.4]
b. 1825 d. 7 Aug 1877 [
=>
]
12
Oscar Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.2.1.5]
b. 24 Nov 1827 d. 7 Jun 1858
12
Harriet Elizabeth Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.2.1.6]
b. 1830 d. 7 Oct 1902
12
Henry Judson Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.2.1.7]
b. 8 Dec 1831 d. 23 Mar 1899 [
=>
]
12
Frances Isabelle Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.2.1.8]
b. 22 Nov 1833 d. 15 Dec 1918 [
=>
]
11
Harriet Fuller Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.2.2]
b. 17 Nov 1798 d. 5 May 1838
Phineas Wood
b. 18 Apr 1800 d. 10 Apr 1866
12
Daughter Wood
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.2.2.1]
b. 1831 d. 24 Aug 1831
12
Charles Phineas Wood
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.2.2.2]
b. 3 Aug 1837 d. 30 Aug 1849
11
Selina Fuller Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.2.3]
b. 24 Dec 1803 d. 19 Apr 1860
Nathaniel Whitcomb Powers
b. 23 Feb 1806 d. 16 Jul 1878
12
Selina Murdock Powers
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.2.3.1]
b. 19 Mar 1846 d. 10 Aug 1932 [
=>
]
11
Eliza Taft Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.2.4]
b. 8 Mar 1808 d. Bef 1812
11
Eliza Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.2.5]
b. 31 Jul 1812
10
Cynthia Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.3]
b. 17 Aug 1773
Nathaniel Butler
b. 1769
11
Cynthia M Butler
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.3.1]
b. 12 Aug 1802 d. 24 Jan 1875
11
George T Butler
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.3.2]
b. 24 Nov 1804 d. 5 Nov 1841
Esther Stone
b. Abt 1806
12
Harvey Butler
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.3.2.1]
b. 11 Nov 1832 d. 20 Feb 1834
12
Rawson Butler
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.3.2.2]
b. 1 Dec 1834
12
Lewis Alphonse Butler
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.3.2.3]
b. 5 Nov 1838
11
Rawson A Butler
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.3.3]
b. 8 Jun 1806 d. 9 Sep 1865
Pamelia Mathews
b. Abt 1817
12
Henry Taft Butler
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.3.3.1]
b. 20 Dec 1840 d. 24 Oct 1869
12
Mary E Butler
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.3.3.2]
b. 5 Jul 1842 d. 22 Aug 1859
12
Cynthia M Butler
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.3.3.3]
b. 24 May 1844
12
George M Butler
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.3.3.4]
b. 10 Dec 1846
12
Edward E Butler
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.3.3.5]
b. 1 May 1849 [
=>
]
12
Frank C Butler
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.3.3.6]
b. 28 Jul 1852 d. 2 Dec 1859
11
Marian Butler
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.3.4]
b. 19 Mar 1809
Rev Elijah Buck
b. 1 Mar 1799 d. 17 Aug 1889
12
Henry Dwight Buck
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.3.4.1]
b. 7 Mar 1834
12
Cynthia Ann Buck
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.3.4.2]
b. 4 Mar 1836
12
Francis Mary Buck
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.3.4.3]
b. 29 Jul 1839 d. 11 Nov 1839
12
Edward Rawson Buck
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.3.4.4]
b. 9 Jan 1842
12
George Nathaniel Buck
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.3.4.5]
b. 15 Aug 1846 [
=>
]
12
Charles Buck
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.3.4.6]
b. 26 Jan 1848 d. 26 Apr 1848
12
Mary Harriett Buck
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.3.4.7]
b. 18 Aug 1849
12
Charles Butler Buck
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.3.4.8]
b. 23 Dec 1851
10
Polly Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.4]
b. 18 Sep 1777 d. 29 Aug 1816
Hezediah Murdock
b. 30 Jun 1776 d. 17 Aug 1864
11
Bazaleel White Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.4.1]
b. 22 Nov 1798 d. 6 Aug 1809
11
Polly Taft Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.4.2]
b. 28 Mar 1803 d. 26 Nov 1846
William Bond
b. 25 May 1796 d. 7 Jul 1838
12
Polly Bond
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.4.2.1]
b. Abt 1822
12
Laura Bond
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.4.2.2]
b. Abt 1824
12
Harriet Bond
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.4.2.3]
b. Abt 1826
12
Lucretia Bond
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.4.2.4]
b. 24 Jul 1826 d. 1883 [
=>
]
12
Orvil Bond
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.4.2.5]
b. Abt 1830
12
Caroline Bond
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.4.2.6]
b. 1 Jul 1831 d. 30 Apr 1909 [
=>
]
12
Charles William Bond
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.4.2.7]
b. 17 Jun 1834 [
=>
]
12
Frances Mary Bond
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.4.2.8]
b. 11 Jan 1837 d. Abt 1873 [
=>
]
11
Stephen Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.4.3]
b. 4 Mar 1801 d. 29 Dec 1889
Eunice Dix
b. 18 Sep 1807 d. 20 Feb 1888
12
Stephen Albert Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.4.3.1]
b. 2 Dec 1830 d. 18 Mar 1835
12
Charles Hrney Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.4.3.2]
b. 30 Mar 1832 d. 18 Nov 1832
12
Eunice Elizabeth Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.4.3.3]
b. 8 Oct 1833 d. 3 Mar 1835
12
Albert S Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.4.3.4]
b. 3 Nov 1834 d. 23 Sep 1915 [
=>
]
12
Edwin Frances Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.4.3.5]
b. 22 Aug 1836 d. 12 Dec 1837
12
Eunice Elizabeth Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.4.3.6]
b. 2 Jan 1840 d. 19 Oct 1882
12
Clarissa Jane Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.4.3.7]
b. 5 Feb 1842 d. 2 Jan 1913
12
Edwin Frances Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.4.3.8]
b. 9 Apr 1844
12
Henry Prescott Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.4.3.9]
b. 13 Jan 1846 d. 4 Jul 1892
12
Frederick Eugene Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.4.3.10]
b. 7 Sep 1847 d. 13 Nov 1899
12
Ella Medora Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.4.3.11]
b. 2 Jan 1852
11
Levi Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.4.4]
b. Abt 1802
11
John Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.4.5]
b. 2 Nov 1806 d. 8 Dec 1891
Mary Cummings
b. 7 Dec 1809 d. 17 Jun 1890
12
Martha Cummings Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.4.5.1]
b. 23 Aug 1841 d. 17 Jan 1873
12
John Grosvenor Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.4.5.2]
b. 2 Apr 1843 d. 22 Feb 1905
12
Adna Cummings Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.4.5.3]
b. 15 Nov 1844 d. 11 Aug 1907
11
Sylvia Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.4.6]
b. 28 Feb 1808 d. 23 Dec 1885
Alvin Cowles
b. Abt 1797
12
Hattie A. Cowles
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.4.6.1]
b. 13 Jan 1833 d. 3 Nov 1913
12
Ellen Cowles
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.4.6.2]
b. 1837 d. 29 Sep 1898 [
=>
]
11
Grosvenor Taft Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.4.7]
b. 29 May 1814 d. 23 Dec 1891
+
Laura Ann Harris
11
Son Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.4.8]
b. 1816 d. 25 May 1816
11
Benjamin Read Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.4.9]
b. 20 Aug 1817 d. 20 Oct 1842
Clarinda Gilmore
b. 1815 d. 16 Sep 1905
12
William Hezekiah Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.4.9.1]
b. 5 May 1841 d. 10 Nov 1920 [
=>
]
11
Sophia Murdock
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.4.10]
b. 31 Aug 1819 d. 21 Oct 1889
Orin Gilmore
b. 1812 d. 26 Apr 1881
12
Kelsey Murdock Gilmore
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.4.10.1]
b. 29 Aug 1840 d. Abt 1909 [
=>
]
12
A. B. Gilmore
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.4.10.2]
b. 22 Aug 1843
10
Zeruiah Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.5]
b. 21 Nov 1779 d. 21 Oct 1852
Major Willard Lovell
b. 1782 d. 1839
11
Lucia Lovell
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.5.1]
b. 19 May 1808
11
Mary Malgretta Lovell
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.5.2]
b. 6 Dec 1809 d. 1857
John Foster Gilkey
b. 1803 d. 8 Aug 1878
12
Edgar H Gilkey
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.5.2.1]
b. Abt 1841
12
Patrick Henry Gilkey
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.5.2.2]
b. Abt 1843 [
=>
]
12
Lucien Gilkey
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.5.2.3]
b. Abt 1845
12
Julian F Gilkey
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.5.2.4]
b. Apr 1850
11
Cynthia Ann Lovell
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.5.3]
b. 29 Apr 1811 d. Bef 1861
11
Elizabeth Adeline Lovell
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.5.4]
b. 4 Mar 1815 d. 29 Aug 1818
11
George Lovell
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.5.5]
b. 9 Dec 1818
11
Enos Lovell
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.5.6]
b. 22 Jul 1821 d. 16 Sep 1821
11
Lafayette Lovell
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.5.7]
b. 27 May 1823
10
Mary Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.6]
b. 12 Jul 1783 d. 7 Feb 1839
+
Nathaniel Stiles
b. 22 Jun 1777 d. 1829
10
Peter Rawson Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.7]
b. 14 Apr 1785 d. 1 Jan 1867
Sylvia Howard
b. 1 Feb 1792 d. 1886
11
Alphonso Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.7.1]
b. 5 Nov 1810 d. 21 May 1891
Fannie Phelps
b. 28 Mar 1823 d. 2 Jun 1851
12
Son Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.7.1.1]
b. 1842 d. 1842
12
Charles P Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.7.1.2]
b. 21 Dec 1842 d. 21 Dec 1929
12
Peter Rawson Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.7.1.3]
b. 10 May 1846 d. 1888 [
=>
]
12
Mary Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.7.1.4]
b. 1848 d. 1848
12
Alphonso Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.7.1.5]
b. 1850 d. 1851
Louisa Maria Torrey
b. 11 Sep 1827 d. 8 Dec 1907
12
Samuel Davenport Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.7.1.6]
b. 7 Feb 1855 d. 1855
12
President William Howard Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.7.1.7]
b. 15 Sep 1857 d. 8 Mar 1930 [
=>
]
12
Henry Waters Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.7.1.8]
b. 27 May 1859 d. 11 Aug 1945 [
=>
]
12
Horace Dutton Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.7.1.9]
b. 28 Sep 1861 d. 28 Jan 1943
12
Alphonso Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.7.1.10]
b. 1865
12
Frances Louise Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.7.1.11]
b. 18 Jul 1865 d. 4 Jan 1950
10
Sophia Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.8]
b. 30 Dec 1787 d. 27 Nov 1843
10
Samuel Judson Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.9]
b. 6 Nov 1791 d. 9 Jun 1867
Lucy C Hayward
b. 1795 d. 21 Dec 1862
11
Sophia Amelia Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.9.1]
d. 12 Dec 1900
George Ropes
b. Mar 1831
12
Ella Elson Ropes
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.9.1.1]
b. 1864
12
Alice Hayward Ropes
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.9.1.2]
b. Feb 1866
12
George H Ropes
[1.1.1.2.6.3.1.3.4.9.1.3]
b. 14 Aug 1868
9
Thankful Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.5]
b. 25 May 1745 d. 26 Oct 1837
Stephen Sibley
b. 12 Jul 1741 d. 25 Aug 1828
10
Joel Sibley
[1.1.1.2.6.3.1.3.5.1]
b. 25 Apr 1766 d. 10 Apr 1839
Lois Louise Woods
b. 24 Jun 1767 d. 21 Nov 1832
11
Amory Sibley
[1.1.1.2.6.3.1.3.5.1.1]
b. 20 Jun 1792 d. 22 Jun 1849
Caroline Bosworth
b. Abt 1796 d. 13 Jan 1858
12
Martha Elmira Sibley
[1.1.1.2.6.3.1.3.5.1.1.1]
b. 16 Oct 1839 d. 1 Oct 1920 [
=>
]
11
Josiah Sibley
[1.1.1.2.6.3.1.3.5.1.2]
b. 1 Apr 1808 d. 7 Dec 1888
Sarah Ann Sophia Crapon
b. 24 Oct 1809 d. 17 May 1858
12
Samuel Hale Sibley
[1.1.1.2.6.3.1.3.5.1.2.1]
b. 9 Sep 1835 d. 1883 [
=>
]
12
William Crapon Sibley
[1.1.1.2.6.3.1.3.5.1.2.2]
b. 3 May 1832 d. 17 Apr 1902 [
=>
]
12
Henry Josiah Sibley
[1.1.1.2.6.3.1.3.5.1.2.3]
b. 19 Nov 1833 d. 25 Jul 1864
12
Sophia Matilda Sibley
[1.1.1.2.6.3.1.3.5.1.2.4]
b. 16 Oct 1837 d. 29 Oct 1897
12
George Royal Sibley
[1.1.1.2.6.3.1.3.5.1.2.5]
b. 19 Jul 1839 d. 15 Jul 1895 [
=>
]
12
Fannie Maria Sibley
[1.1.1.2.6.3.1.3.5.1.2.6]
b. 13 Oct 1841 d. 20 Dec 1842
12
Mary Lois Sibley
[1.1.1.2.6.3.1.3.5.1.2.7]
b. 3 Sep 1843 d. 23 Feb 1864
12
Alice Marie Sibley
[1.1.1.2.6.3.1.3.5.1.2.8]
b. 9 Feb 1846 d. 13 Jul 1907
12
Robert Pendelton Sibley
[1.1.1.2.6.3.1.3.5.1.2.9]
b. Abt 1847 [
=>
]
12
Caroline Crapon Sibley
[1.1.1.2.6.3.1.3.5.1.2.10]
b. 21 Feb 1850 d. 16 Nov 1858
12
Amory Walter Sibley
[1.1.1.2.6.3.1.3.5.1.2.11]
b. 19 Jun 1852 d. 28 Jul 1899
12
Josiah Sibley
[1.1.1.2.6.3.1.3.5.1.2.12]
b. 1866 d. 1879
Emaline Eve
b. 1839
12
John Adam Sibley
[1.1.1.2.6.3.1.3.5.1.2.13]
b. 1 Sep 1861 d. 26 Mar 1934
12
James Longstreet Sibley
[1.1.1.2.6.3.1.3.5.1.2.14]
b. 4 Aug 1863 d. 10 Sep 1945 [
=>
]
12
Mary Bones Sibley
[1.1.1.2.6.3.1.3.5.1.2.15]
b. 29 Mar 1865 d. 22 Jun 1954
12
Emma Josephine Sibley
[1.1.1.2.6.3.1.3.5.1.2.16]
b. 23 Feb 1867 d. 25 Oct 1957 [
=>
]
10
Lydia Sibley
[1.1.1.2.6.3.1.3.5.2]
b. 2 Apr 1769 d. 27 Nov 1822
Henry Staples Benson
b. 8 Aug 1770 d. 29 Jul 1821
11
Abigail Benson
[1.1.1.2.6.3.1.3.5.2.1]
b. 31 Mar 1795 d. 10 Nov 1821
Asa Legg
b. 7 May 1792 d. 15 Nov 1836
12
Charlotte Legg
[1.1.1.2.6.3.1.3.5.2.1.1]
b. 2 May 1818 d. 30 Oct 1900 [
=>
]
12
Lyman Legg
[1.1.1.2.6.3.1.3.5.2.1.2]
b. 3 Sep 1822 d. 1 Sep 1904 [
=>
]
11
Harriet Benson
[1.1.1.2.6.3.1.3.5.2.2]
b. 14 Sep 1796 d. 22 Aug 1852
11
Mellen Benson
[1.1.1.2.6.3.1.3.5.2.3]
b. 14 Jan 1798
Eliza W Farnum
b. 25 Sep 1802 d. 14 Sep 1839
12
Henry Staples Benson
[1.1.1.2.6.3.1.3.5.2.3.1]
b. 17 May 1829
12
Almira Farnum Benson
[1.1.1.2.6.3.1.3.5.2.3.2]
b. 6 Aug 1830 d. 25 Dec 1835
12
James Haskins Benson
[1.1.1.2.6.3.1.3.5.2.3.3]
b. 16 Oct 1833
12
George Everett Benson
[1.1.1.2.6.3.1.3.5.2.3.4]
b. 14 Aug 1837
+
Mary Windsor Peck
b. 21 May 1798
11
Hannah Adaline Benson
[1.1.1.2.6.3.1.3.5.2.4]
b. 12 Aug 1802 d. 19 Jun 1822
11
Rufus Benson
[1.1.1.2.6.3.1.3.5.2.5]
b. 24 Jan 1804 d. 23 Aug 1805
11
Chloe Ann Benson
[1.1.1.2.6.3.1.3.5.2.6]
b. 23 Aug 1806
+
Dan Hill
b. 29 Nov 1796
11
Susan Augusta Benson
[1.1.1.2.6.3.1.3.5.2.7]
b. 9 Oct 1809 d. 25 Jul 1831
Preserved Smith Thayer
b. 9 May 1808
12
Susan Benson Thayer
[1.1.1.2.6.3.1.3.5.2.7.1]
b. 28 Jun 1831 d. 14 Aug 1909
11
Rufus Aldrich Benson
[1.1.1.2.6.3.1.3.5.2.8]
b. 9 Oct 1809
+
Sarah E Buell
11
Stephen Sibley Benson
[1.1.1.2.6.3.1.3.5.2.9]
b. 9 Jan 1810 d. 20 Nov 1869
Elizabeth Richardson Scott
b. 8 Jan 1835 d. 20 Feb 1911
12
Jessie Harriet Benson
[1.1.1.2.6.3.1.3.5.2.9.1]
b. 7 Jun 1860
12
Fred Mellen Benson
[1.1.1.2.6.3.1.3.5.2.9.2]
b. 10 Nov 1862 d. 9 May 1864
12
Susie Adeline Benson
[1.1.1.2.6.3.1.3.5.2.9.3]
b. 6 Aug 1865
9
Joel Taft
[1.1.1.2.6.3.1.3.6]
b. 28 May 1747 d. 27 Sep 1758
8
Sarah Taft
[1.1.1.2.6.3.1.4]
b. 9 Mar 1719
8
Captain Joseph Taft
[1.1.1.2.6.3.1.5]
b. 19 Apr 1722 d. 25 Dec 1787
Elizabeth Thayer
b. 13 Feb 1724 d. 27 Aug 1797
9
Rueben Taft
[1.1.1.2.6.3.1.5.1]
b. 21 Oct 1742 d. Aft 1761
Faithful Thayer
b. 18 Jun 1744 d. 1827
10
Susannah Taft
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.1]
b. 27 Dec 1761 d. 14 Nov 1825
Isaac Dresser
b. 22 Feb 1759 d. 4 Dec 1835
11
Reuben Dresser
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.1.1]
b. 11 Jun 1781 d. 5 Sep 1782
11
Betsey Dresser
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.1.2]
b. 22 May 1783
11
Polly Dresser
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.1.3]
b. 14 Jun 1785
11
Leonard Dresser
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.1.4]
b. 7 Aug 1787 d. 26 Apr 1838
Mary Thombs
b. 25 Dec 1790 d. 27 Aug 1866
12
Clarissa Codelia Dresser
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.1.4.1]
b. 8 Nov 1812
12
Joseph Western Dresser
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.1.4.2]
b. 7 Jun 1814
12
Leonard Augustus Dresser
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.1.4.3]
b. 1 Dec 1815 d. 27 Jun 1875 [
=>
]
12
Mary Diana Dresser
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.1.4.4]
b. 6 Dec 1817 d. 30 Nov 1833
12
Sarah Diana Dresser
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.1.4.5]
b. 21 Mar 1819 [
=>
]
12
Emily Dresser
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.1.4.6]
b. 25 Dec 1821 d. 25 Dec 1900 [
=>
]
12
James Volna Dresser
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.1.4.7]
b. 2 Mar 1823 d. 18 Jun 1826
12
Electa Dresser
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.1.4.8]
b. 18 Aug 1825
12
Eliza Jane Dresser
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.1.4.9]
b. 30 Apr 1827 [
=>
]
12
Louisa Dresser
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.1.4.10]
b. 27 Oct 1830 d. 8 Dec 1907 [
=>
]
12
John Quincy Dresser
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.1.4.11]
b. 20 Sep 1832 d. 16 Apr 1918 [
=>
]
11
Clarissa Dresser
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.1.5]
b. 4 Sep 1789 d. 5 Aug 1867
Roderick Random Stewart
b. 25 Feb 1787 d. 12 Jul 1860
12
Isaac Newton Stewart
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.1.5.1]
b. 12 Oct 1814 d. 23 Apr 1883
12
Narcissa Random Stewart
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.1.5.2]
b. 25 Feb 1816 d. 17 Mar 1850
12
Elisha Milton Stewart
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.1.5.3]
b. 28 Jun 1818 d. 3 Jul 1899 [
=>
]
12
Susannah Dresser Stewart
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.1.5.4]
b. 28 Jan 1820 d. 8 Jun 1889 [
=>
]
12
Permelia Taft Stewart
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.1.5.5]
b. 7 Jun 1822 d. 4 Dec 1897 [
=>
]
12
La Fayette Stewart
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.1.5.6]
b. 21 Jun 1824 d. 17 Jun 1898 [
=>
]
12
Josiah Taft Stewart
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.1.5.7]
b. 6 Oct 1828 d. 1 Jan 1855
12
George Washington Stewart
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.1.5.8]
b. 27 Jan 1830 d. 20 Feb 1902 [
=>
]
11
Susanna Dresser
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.1.6]
b. 3 Nov 1791
+
Jonathan Gould
b. Abt 1788
11
Isaac Dresser
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.1.7]
b. 19 May 1793 d. 5 Feb 1862
Laura Frary
b. 2 Nov 1802 d. Aug 1858
12
James Munroe Dresser
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.1.7.1]
b. 6 Dec 1820 d. 13 Nov 1833
12
Justus Frary Dresser
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.1.7.2]
b. 21 Nov 1822 d. 1824
12
Justus Frary Dresser
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.1.7.3]
b. 7 Nov 1825 d. 1 Jan 1881 [
=>
]
12
Theda Dresser
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.1.7.4]
b. 9 Sep 1827 d. 31 Oct 1895
12
Clarissa Susannah Dresser
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.1.7.5]
b. 30 Nov 1832 d. 20 Jan 1852
12
Eliza Rebecca Dresser
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.1.7.6]
b. 7 Feb 1841 d. 9 Sep 1843
+
Emily Marcy
b. Abt 1805
11
Diana Dresser
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.1.8]
b. 17 Dec 1795
11
David Dresser
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.1.9]
b. 12 Sep 1797
Dorcas Williams
b. 18 Apr 1794
12
Gilbert W Dresser
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.1.9.1]
b. Abt 1819 d. 17 Jul 1856 [
=>
]
10
Nancy Taft
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.2]
b. 9 Jul 1763 d. 1835
10
Rhoxanna Taft
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.3]
b. 14 Aug 1765 d. 1837
+
Josiah Wood
10
Diana Taft
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.4]
b. 4 Sep 1767 d. 1830
+
Silvanus Thayer
b. 4 Sep 1762
10
Joseph Taft
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.5]
b. 26 Jun 1769
10
Marcy Taft
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.6]
b. 11 Aug 1771 d. 1840
10
Polly Taft
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.7]
b. 9 Jun 1773 d. 26 Oct 1848
Jesse Hurlbut
b. 21 Jul 1769 d. 11 Jan 1848
11
Polly Hurlbut
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.7.1]
b. 27 Apr 1793 d. 17 Sep 1861
John William Wilcox
b. 8 Jun 1793 d. 17 Sep 1861
12
Stephen Dorman Wilcox
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.7.1.1]
b. Abt 1815 d. 22 Jan 1863 [
=>
]
12
Roxana Wilcox
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.7.1.2]
b. Abt 1817 d. 1820
12
Montreville Russell Wilcox
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.7.1.3]
b. 4 Sep 1826 d. 13 Jan 1888 [
=>
]
11
Reuben Hurlbut
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.7.2]
b. 7 Apr 1794 d. 28 May 1879
Hannah Moore
b. 1794 d. 18 Nov 1861
12
Diana S Hurlbut
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.7.2.1]
b. 12 Nov 1816
12
Polly A Hurlbut
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.7.2.2]
b. 27 Nov 1818
12
Sarah Ann Hurlburt
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.7.2.3]
b. 26 Jul 1820 d. 23 Apr 1908 [
=>
]
12
Chauncey Hurlbut
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.7.2.4]
b. 7 Nov 1822
12
Marmary Annette Hurlbut
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.7.2.5]
b. 12 Sep 1824 d. 14 May 1914
12
Edwin Taft Monroe Hurlbut
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.7.2.6]
b. 20 Jun 1828 [
=>
]
12
Iantha C Hurlbut
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.7.2.7]
b. 31 May 1826
12
Seth Hurlbut
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.7.2.8]
b. 12 Jul 1833
12
Sylvia Hurlbut
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.7.2.9]
b. 7 Feb 1836
11
Aseneth Hurlbut
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.7.3]
b. 7 Jan 1797 d. 26 May 1875
Bechias Dustin
b. 5 Oct 1793 d. 6 Nov 1874
12
David Dustin
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.7.3.1]
b. 15 Feb 1817 d. 25 Jun 1893 [
=>
]
12
Fornatus Dustin
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.7.3.2]
b. 17 Feb 1820 d. 11 Oct 1872 [
=>
]
12
Bechias Dustin
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.7.3.3]
b. 21 Oct 1823 d. Aft 1870
12
Seth Dustin
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.7.3.4]
b. 21 Oct 1825 d. 2 Dec 1903 [
=>
]
12
Joseph Dustin
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.7.3.5]
b. 15 Dec 1827 d. 10 Dec 1914 [
=>
]
12
Aseneth Cecilia Dustin
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.7.3.6]
b. 25 Feb 1829 d. Mar 1899 [
=>
]
12
Roxanna Mahalia Dustin
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.7.3.7]
b. 3 Jul 1833 d. 11 Mar 1903 [
=>
]
12
Franklin Dustin
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.7.3.8]
b. 1834 d. Aft 1885
12
Christopher Dustin
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.7.3.9]
b. 1837 d. 12 Aug 1898
12
Andrew Dustin
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.7.3.10]
d. Bef 1845
11
Diana Hurlbut
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.7.4]
b. 29 Mar 1798 d. 1 Mar 1841
+
George Fox
b. 1794
11
Alma Hurlbut
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.7.5]
b. 13 Feb 1800
+
Reed
b. Abt 1796
11
Hiram Higgins Hurlbut
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.7.6]
b. 29 Nov 1801 d. 20 Jul 1864
Lydia McIntyre
b. 18 Aug 1805
12
Mary Hurlbut
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.7.6.1]
b. 27 Jun 1826 d. 7 Jul 1865
12
Sarah Hurlbut
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.7.6.2]
b. 2 Sep 1827
12
Esther Mahala Hurlburt
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.7.6.3]
b. 20 Jan 1829
12
Jesse Hurlbut
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.7.6.4]
b. 13 Nov 1830 d. 25 Jul 1874 [
=>
]
12
Matilda Hurlbut
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.7.6.5]
b. 7 Jun 1832
12
Urilla Hurlbut
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.7.6.6]
b. 20 Mar 1834
12
Stephen Hulbert
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.7.6.7]
b. 28 Dec 1836 d. 1882 [
=>
]
12
Lydia Hurlbut
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.7.6.8]
b. 5 May 1838
12
Hiram Hurlbut
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.7.6.9]
b. 6 Aug 1840
12
John William Hurlbut
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.7.6.10]
b. 28 Feb 1843 [
=>
]
11
Horatio Hurlbut
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.7.7]
b. 9 Nov 1806 d. 1890
Sabrina Lumbard
b. 1 Sep 1812
12
Vincent Lumbard Hurlbut
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.7.7.1]
b. 28 Jan 1829
11
Quartus Ovando Hurlbut
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.7.8]
b. 7 Feb 1804 d. 10 Jan 1879
+
Hetty Dann
b. Abt 1808
10
Ruth Taft
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.8]
b. 5 Jul 1778 d. 1860
William Smith
b. Abt 1779
11
Thomas Smith
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.8.1]
b. Abt 1803 d. 21 Feb 1884
10
Betsy Taft
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.9]
b. 24 Mar 1776 d. Feb 1853
Moses Chapin
b. 24 May 1776 d. 19 Jul 1844
11
Joseph Chapin
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.9.1]
b. 15 Jul 1797 d. 12 Jun 1857
Louisa Veaux
b. Abt 1801
12
Sarah Chapin
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.9.1.1]
b. 3 Dec 1825
12
Caroline Chapin
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.9.1.2]
c. 14 Aug 1828 d. 20 Aug 1843
Harriet Elizabeth Voax
b. 18 Jul 1821 d. 23 Sep 1872
12
Joseph Chapin
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.9.1.3]
b. 6 May 1845 d. 22 Aug 1846
12
Harriet Louise Chapin
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.9.1.4]
b. 9 Mar 1848
12
Ann Elizabeth Chapin
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.9.1.5]
b. 10 Feb 1851 d. 22 Jun 1853
11
Stephen Chapin
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.9.2]
b. 4 Jan 1801 d. 9 Mar 1843
Julia Emily Taft
b. 1807
12
Moses Williams Chapin
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.9.2.1]
b. 10 Jun 1829 d. 7 May 1884 [
=>
]
11
Ruth Adaline Chapin
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.9.3]
b. 24 Oct 1802 d. 1862
William Thornton
b. Abt 1798 d. 1862
12
Sylvia Taft Thornton
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.9.3.1]
b. 2 Jan 1833
12
William Handy Thornton
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.9.3.2]
b. 16 Jan 1837
12
John Green Thornton
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.9.3.3]
b. 11 Mar 1841
11
Orris Taft Chapin
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.9.4]
b. 27 Jan 1805 d. 20 Dec 1849
Martha Dickson
b. 9 Jan 1804 d. 16 Mar 1856
12
Thomas Rundle Chapin
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.9.4.1]
b. 11 Oct 1829 d. 24 Feb 1905 [
=>
]
12
Augustine Francis Chapin
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.9.4.2]
b. 9 Jan 1832 d. 6 Jul 1868 [
=>
]
12
Luthera Chapin
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.9.4.3]
b. Abt 1834
11
Betsy Taft Chapin
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.9.5]
b. 14 Oct 1807 d. 21 Apr 1838
Parley Gould
b. 17 Sep 1807 d. 16 Jan 1877
12
Luthera Gould
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.9.5.1]
b. 15 Jul 1833 d. 13 Oct 1862
12
Augustine Gould
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.9.5.2]
b. 18 Mar 1835 [
=>
]
11
Abigail Adams Chapin
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.9.6]
b. 4 Sep 1809 d. 6 Aug 1854
Benedict Arnold Greene
b. 17 Jan 1812 d. 12 Jan 1858
12
Robert E Greene
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.9.6.1]
b. 2 Mar 1845
12
Julia Amanda Greene
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.9.6.2]
b. 27 Feb 1847 d. Feb 1853
12
Moses Chapin Greene
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.9.6.3]
b. 15 Apr 1849 d. 1849
12
Walter Ernest Greene
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.9.6.4]
b. 1850
11
Diana Maria Chapin
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.9.7]
b. 9 Mar 1812 d. 23 Aug 1854
Richard Waterman
b. 4 Aug 1809 d. 1883
12
Abbie Maria Waterman
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.9.7.1]
b. 29 Mar 1835 d. 1906 [
=>
]
12
Louisa Chapin Waterman
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.9.7.2]
b. 23 Jul 1837 d. 25 Jul 1837
12
Elizabeth Slade Waterman
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.9.7.3]
b. 23 Jul 1837
12
Caroline Chapin Waterman
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.9.7.4]
b. 5 Dec 1844 d. 11 Mar 1848
12
John Waterman
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.9.7.5]
b. 7 Mar 1847 d. 26 Feb 1918
12
Thomas Warner Waterman
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.9.7.6]
b. 8 Jun 1849
12
Fannie Alice Waterman
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.9.7.7]
b. 24 Oct 1851 d. 21 Sep 1853
12
Frank Arthur Waterman
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.9.7.8]
b. 24 Oct 1852
11
Moses Smeadley Chapin
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.9.8]
b. 15 Aug 1816 d. 14 Nov 1819
11
Adaline Chapin
[1.1.1.2.6.3.1.5.1.9.9]
b. 14 May 1820 d. 1904
9
Lucy Taft
[1.1.1.2.6.3.1.5.2]
b. 5 Mar 1745 d. 1822
9
Silas Taft
[1.1.1.2.6.3.1.5.3]
b. 22 Nov 1747
9
Sarah Taft
[1.1.1.2.6.3.1.5.4]
b. 8 Mar 1750 d. 3 May 1811
9
Asahel Taft
[1.1.1.2.6.3.1.5.5]
b. 30 Jul 1752 d. Nov 1826
Rachel Alton
b. 9 Mar 1760 d. 5 Aug 1851
10
Silas Taft
[1.1.1.2.6.3.1.5.5.1]
b. 21 Oct 1780
10
Elizabeth Taft
[1.1.1.2.6.3.1.5.5.2]
b. 17 Mar 1783
10
Rachel Taft
[1.1.1.2.6.3.1.5.5.3]
b. Abt 1785
10
Mary Taft
[1.1.1.2.6.3.1.5.5.4]
b. 1787
10
Asahel J Taft
[1.1.1.2.6.3.1.5.5.5]
b. 1792
10
Joseph Taft
[1.1.1.2.6.3.1.5.5.6]
b. 15 Jun 1794
10
Sarah Taft
[1.1.1.2.6.3.1.5.5.7]
b. 28 Feb 1797 d. 29 Sep 1879
Wheaton W Wilson
b. 5 Aug 1787 d. 13 Jan 1874
11
Wheaton Wilson
[1.1.1.2.6.3.1.5.5.7.1]
b. 10 Nov 1817 d. 17 Aug 1900
11
Mary Wilson
[1.1.1.2.6.3.1.5.5.7.2]
b. 7 Sep 1820 d. 23 Nov 1887
11
Fanny Maria Wilson
[1.1.1.2.6.3.1.5.5.7.3]
b. 12 Sep 1822 d. 1900
11
Alonzo Wilson
[1.1.1.2.6.3.1.5.5.7.4]
b. 19 Sep 1824 d. 13 Oct 1826
11
Emily Wilson
[1.1.1.2.6.3.1.5.5.7.5]
b. 7 May 1827
11
Sophia Wilson
[1.1.1.2.6.3.1.5.5.7.6]
b. 19 Jul 1829 d. 9 Apr 1919
11
Caroline Louisa Wilson
[1.1.1.2.6.3.1.5.5.7.7]
b. 4 Mar 1832 d. 11 Mar 1892
11
John Wilson
[1.1.1.2.6.3.1.5.5.7.8]
b. 26 May 1834
11
William Walter Wilson
[1.1.1.2.6.3.1.5.5.7.9]
b. 8 Sep 1836 d. 31 Jul 1839
11
Wallace Warren Wilson
[1.1.1.2.6.3.1.5.5.7.10]
b. 28 Sep 1839 d. 22 Oct 1906
Sarah A Samson
b. 6 Dec 1842 d. 30 Apr 1915
12
Clarence Wallace Wilson
[1.1.1.2.6.3.1.5.5.7.10.1]
b. Jul 1861 d. 7 Feb 1904 [
=>
]
12
Mable Wilson
[1.1.1.2.6.3.1.5.5.7.10.2]
b. 17 Mar 1865 d. 31 Mar 1873
12
William A Wilson
[1.1.1.2.6.3.1.5.5.7.10.3]
b. 2 Jul 1866 d. 21 Nov 1904 [
=>
]
12
Albert Wilson
[1.1.1.2.6.3.1.5.5.7.10.4]
b. 1870
12
Walter Gordon Wilson
[1.1.1.2.6.3.1.5.5.7.10.5]
b. 20 Dec 1873 d. 20 Mar 1914 [
=>
]
12
Everett Wilson
[1.1.1.2.6.3.1.5.5.7.10.6]
b. 20 Jul 1878 d. 7 Jan 1884
12
Lena L Wilson
[1.1.1.2.6.3.1.5.5.7.10.7]
b. 11 Oct 1883 d. 21 Dec 1883
12
Maud E Wilson
[1.1.1.2.6.3.1.5.5.7.10.8]
b. 1886 d. 24 Jan 1907 [
=>
]
10
Fannie Taft
[1.1.1.2.6.3.1.5.5.8]
b. 14 Jan 1801 d. 3 Sep 1867
10
Emily Taft
[1.1.1.2.6.3.1.5.5.9]
b. 8 Mar 1803
9
Ezra Taft
[1.1.1.2.6.3.1.5.6]
b. 22 Dec 1752 d. Aft 1803
9
Ruth Taft
[1.1.1.2.6.3.1.5.7]
b. 13 May 1763
8
Elizabeth Taft
[1.1.1.2.6.3.1.6]
b. 30 Oct 1724
Jonathan Penniman
b. 30 Jul 1719 d. 18 Jul 1747
9
Jonathan Peniman
[1.1.1.2.6.3.1.6.1]
b. 21 Mar 1744 d. 2 Sep 1761
9
Mary Peniman
[1.1.1.2.6.3.1.6.2]
b. 27 Oct 1746 d. 5 Jul 1749
9
Ann Peniman
[1.1.1.2.6.3.1.6.3]
b. 26 Aug 1749
9
Adna Penniman
[1.1.1.2.6.3.1.6.4]
b. 5 Oct 1752 d. 4 Nov 1820
9
Bethiah Peniman
[1.1.1.2.6.3.1.6.5]
b. 12 Nov 1758
9
Nathan Peniman
[1.1.1.2.6.3.1.6.6]
b. 26 Nov 1766 d. 11 Jun 1831
8
Aaron Taft
[1.1.1.2.6.3.1.7]
b. 12 Apr 1727 d. 5 Nov 1805
Marcy Arnold
b. 24 Jan 1733 d. 22 Jan 1806
9
Rhoda Taft
[1.1.1.2.6.3.1.7.1]
b. 4 Feb 1753 d. 4 Apr 1837
9
Arnold Taft
[1.1.1.2.6.3.1.7.2]
b. 4 May 1756
9
Thaddeus Taft
[1.1.1.2.6.3.1.7.3]
b. 13 Dec 1757 d. 5 Sep 1831
9
Patiance Taft
[1.1.1.2.6.3.1.7.4]
b. 1 Sep 1761 d. 26 Nov 1816
9
Zadock Taft
[1.1.1.2.6.3.1.7.5]
b. 15 Aug 1763 d. 15 Nov 1843
9
Willis Taft
[1.1.1.2.6.3.1.7.6]
b. 13 Aug 1765 d. 6 Dec 1841
8
Margaret Taft
[1.1.1.2.6.3.1.8]
b. 9 Feb 1729
7
Sarah Emerson
[1.1.1.2.6.3.2]
b. Aft 1687
7
Thomas Emerson
[1.1.1.2.6.3.3]
b. 13 Mar 1692 d. 21 Dec 1747
7
John Emerson
[1.1.1.2.6.3.4]
b. 9 Jun 1694 d. 1780
7
Joseph Emerson
[1.1.1.2.6.3.5]
b. 18 Dec 1696 d. 1745
7
Ebenezer Emerson
[1.1.1.2.6.3.6]
b. 1698 d. 1747
7
Nathanial Emerson
[1.1.1.2.6.3.7]
b. Abt 1705
6
Daughter Ingersoll
[1.1.1.2.6.4]
b. Abt 1665
4
William Ingersoll
[1.1.1.3]
b. 1589 d. 17 Nov 1590
4
John Ingersoll
[1.1.1.4]
b. 1594 d. 3 Sep 1684
4
Elisabeth Ingersoll
[1.1.1.5]
b. 22 Oct 1597