Home Page
|
What's New
|
Photos
|
Histories
|
Headstones
|
Reports
|
Surnames
Search
First Name:
Last Name:
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Suomalainen
Svenska
John Boithes
1525 - 1569 (44 years)
Submit Photo / Document
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Submit Photo / Doc
Worksheet
Family
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
John Boithes
[1]
b. 1525 d. 27 Mar 1569
Isabella Swift
b. 1531 d. 1557
2
Thomas Boithes
[1.1]
b. 1550
2
Isabella Boithes
[1.2]
b. 1552
2
Robert Boithes
[1.3]
b. 1552
2
Henry Boithes
[1.4]
c. 26 Jan 1555
2
Genet Boithes
[1.5]
c. 2 Jul 1555
2
Grace Boithes
[1.6]
c. 16 Jul 1557 d. 9 Mar 1628
Henry Best
b. 20 Apr 1554 d. Sep 1622
3
Michael Best
[1.6.1]
b. 14 Aug 1578
3
Judith Best
[1.6.2]
b. 12 Feb 1580
3
John Best
[1.6.3]
b. Abt 1584 d. 21 Jun 1654
Jane Robinsonne
b. 1587 d. 1607
4
Elizabeth Best
[1.6.3.1]
b. 1607 d. 27 Feb 1661
William Enos Hunt
b. 25 Jan 1604 d. 2 Oct 1677
5
Nehemiah Hunt
[1.6.3.1.1]
b. Jun 1631 d. 6 Mar 1717
Mary Toll
b. 8 Dec 1643 d. 29 Aug 1727
6
Mary Hunt
[1.6.3.1.1.1]
b. 28 Sep 1664 d. 1 Dec 1702
Thomas Wood
b. 10 Aug 1658 d. 1 Dec 1702
7
Mary Wood
[1.6.3.1.1.1.1]
b. 29 Aug 1684 d. 12 Dec 1774
Daniel Pearson
b. 25 Dec 1684 d. 8 Jun 1759
8
Simon Pearson
[1.6.3.1.1.1.1.1]
b. 7 Nov 1709
Ruth Taylor
b. 3 Apr 1712
9
Ruth Pearson
[1.6.3.1.1.1.1.1.1]
b. 21 Oct 1739
9
Benjamin Person
[1.6.3.1.1.1.1.1.2]
b. 21 May 1742
9
Ezra Pearson
[1.6.3.1.1.1.1.1.3]
b. 16 Apr 1744 d. 30 Dec 1800
Anne Fuller
b. 1741 d. Aft 1810
10
Lucinda Pearson
[1.6.3.1.1.1.1.1.3.1]
b. 29 Jan 1767
+
Ezekiel Barton
b. Abt 1767
10
Lieutenant Adin Pearson
[1.6.3.1.1.1.1.1.3.2]
b. 28 Nov 1768 d. 7 Jun 1853
Eunice Brooks
b. 3 Oct 1771 d. 24 Nov 1801
11
Lucina Pearson
[1.6.3.1.1.1.1.1.3.2.1]
b. 16 Jul 1789 d. 6 Sep 1878
Jonathan Harvey Andrus
b. 18 Feb 1783 d. 18 Jan 1875
12
Orrin Clark Andrus
[1.6.3.1.1.1.1.1.3.2.1.1]
b. 9 Dec 1807 d. 19 May 1885 [
=>
]
12
Pamelia Andrus
[1.6.3.1.1.1.1.1.3.2.1.2]
b. 21 Oct 1809 d. 14 Sep 1877 [
=>
]
12
Adeline Brooks Andrus
[1.6.3.1.1.1.1.1.3.2.1.3]
b. 18 Mar 1813 d. 20 Apr 1898 [
=>
]
12
Walter Harvey Andrus
[1.6.3.1.1.1.1.1.3.2.1.4]
b. 3 Feb 1815 d. 24 Jan 1898
12
Lucina Andrus
[1.6.3.1.1.1.1.1.3.2.1.5]
b. 24 Jul 1817 d. 27 Mar 1891 [
=>
]
12
Adin Parsons Andrus
[1.6.3.1.1.1.1.1.3.2.1.6]
b. 27 Aug 1820 d. 4 Nov 1899
12
Harriet Warner Andrus
[1.6.3.1.1.1.1.1.3.2.1.7]
b. 26 Sep 1824 d. 17 Mar 1890
12
Annie Marie Andrus
[1.6.3.1.1.1.1.1.3.2.1.8]
b. 25 Oct 1827 d. 14 Feb 1881
12
Caroline Adelia Andrus
[1.6.3.1.1.1.1.1.3.2.1.9]
b. 6 Feb 1830 d. 18 Aug 1904
11
Warren Pearson
[1.6.3.1.1.1.1.1.3.2.2]
b. 23 Jul 1792
11
Loren Pearson
[1.6.3.1.1.1.1.1.3.2.3]
b. 5 Oct 1797 d. 19 Jul 1861
10
Zelotes Pearson
[1.6.3.1.1.1.1.1.3.3]
b. 9 Sep 1771
+
Anna
b. Abt 1771
10
Clarice Pearson
[1.6.3.1.1.1.1.1.3.4]
b. 11 Feb 1774
+
John Little
b. Abt 1774
10
Jerusha Pearson
[1.6.3.1.1.1.1.1.3.5]
b. 15 Aug 1776 d. 9 Feb 1874
+
Gates Willey
b. Abt 1776
10
Anna Pearson
[1.6.3.1.1.1.1.1.3.6]
b. 2 Feb 1779 d. 26 Jan 1830
Elam Wright
b. 1 Dec 1774 d. 6 Feb 1831
11
Elam G Wright
[1.6.3.1.1.1.1.1.3.6.1]
b. 10 Feb 1811
11
Alvira Lucretia Wright
[1.6.3.1.1.1.1.1.3.6.2]
b. 17 Aug 1815
11
Vienna Wright
[1.6.3.1.1.1.1.1.3.6.3]
b. 28 Oct 1817 d. 29 Nov 1909
8
Ephraim Pearson
[1.6.3.1.1.1.1.2]
c. 25 Nov 1711
James Dickinson
b. 30 Jun 1678 d. 5 Jan 1705
8
Mary Dickinson
[1.6.3.1.1.1.1.3]
b. 29 Nov 1703 d. 8 Jun 1759
8
James Dickinson
[1.6.3.1.1.1.1.4]
b. 31 Dec 1705 d. 27 Jun 1756
Ruth Hartshorn
b. 12 May 1706 d. Aft 1750
9
Mary Dickinson
[1.6.3.1.1.1.1.4.1]
b. 20 Feb 1728
9
Submit Dickinson
[1.6.3.1.1.1.1.4.2]
b. 29 Jun 1731 d. 1788
9
Ruth Dickson
[1.6.3.1.1.1.1.4.3]
b. 3 Mar 1734
9
James Dickinson
[1.6.3.1.1.1.1.4.4]
b. 1 Aug 1736 d. Aft 1775
9
Jonathan Dickinson
[1.6.3.1.1.1.1.4.5]
b. 18 Nov 1738 d. 16 Oct 1762
Abigail Whipple
b. 30 Jan 1729 d. 21 Apr 1806
10
Mary Dickinson
[1.6.3.1.1.1.1.4.5.1]
b. 25 Dec 1758 d. 5 Mar 1759
10
Jonathan Dickinson
[1.6.3.1.1.1.1.4.5.2]
b. 30 Sep 1760
10
Mary Dickinson
[1.6.3.1.1.1.1.4.5.3]
b. Mar 1762 d. May 1850
9
Noah Dickinson
[1.6.3.1.1.1.1.4.6]
b. 14 Mar 1741 d. 16 Jan 1828
9
Mathew Dickinson
[1.6.3.1.1.1.1.4.7]
b. 14 Apr 1743 d. 21 Sep 1762
9
Ruth Dickinson
[1.6.3.1.1.1.1.4.8]
b. 29 Jul 1745 d. 22 Nov 1834
9
Love Dickinson
[1.6.3.1.1.1.1.4.9]
b. 2 Jun 1750
7
Thomas Wood
[1.6.3.1.1.1.2]
b. 18 Sep 1686 d. 27 Sep 1760
Abigail Hartshorn
b. 29 Sep 1686 d. 22 Sep 1760
8
Thomas Wood
[1.6.3.1.1.1.2.1]
b. 5 Feb 1711 d. 1777
Mary Lashley
b. 25 Mar 1711 d. Abt Dec 1809
9
John Wood
[1.6.3.1.1.1.2.1.1]
b. 13 Sep 1733
9
Elizabeth Wood
[1.6.3.1.1.1.2.1.2]
b. 20 Jul 1735 d. 1795
9
Johannah Wood
[1.6.3.1.1.1.2.1.3]
b. 22 Jun 1737 d. 3 Jun 1805
9
Alice Wood
[1.6.3.1.1.1.2.1.4]
b. 1738
9
Elijah Wood
[1.6.3.1.1.1.2.1.5]
b. 1739 d. Feb 1805
9
Lashley Levi Wood
[1.6.3.1.1.1.2.1.6]
b. 1740 d. 15 Aug 1809
Mary Mersey Lucas
b. Jan 1740 d. 1809
10
Mary Wood
[1.6.3.1.1.1.2.1.6.1]
c. 8 Apr 1764 d. 1840
John W Ogden
b. 1763 d. Apr 1824
11
Sarah Ogden
[1.6.3.1.1.1.2.1.6.1.1]
b. 1784
11
John W Ogden
[1.6.3.1.1.1.2.1.6.1.2]
b. 1786 d. 1830
11
Joseph Ogden
[1.6.3.1.1.1.2.1.6.1.3]
b. 1788 d. 1 Nov 1854
11
Otho W Ogden
[1.6.3.1.1.1.2.1.6.1.4]
b. 1792 d. 5 Apr 1816
Susannah Hansbrough
b. 31 Mar 1799 d. 4 Nov 1850
12
Susan Hansborough Ogden
[1.6.3.1.1.1.2.1.6.1.4.1]
b. 10 Oct 1820 d. 21 Nov 1902 [
=>
]
11
James Ogden
[1.6.3.1.1.1.2.1.6.1.5]
b. 29 Nov 1792 d. 24 Aug 1852
11
Thomas Ogden
[1.6.3.1.1.1.2.1.6.1.6]
b. Abt 1796 d. Bef 25 Jul 1845
11
Elias Ogden
[1.6.3.1.1.1.2.1.6.1.7]
b. 1798 d. 1847
11
Polly Ogden
[1.6.3.1.1.1.2.1.6.1.8]
b. 1800
10
Leatha Ann Wood
[1.6.3.1.1.1.2.1.6.2]
b. 10 Aug 1766 d. 1831
10
John Wood
[1.6.3.1.1.1.2.1.6.3]
b. 10 Aug 1768 d. 15 Sep 1853
10
Basil Wood
[1.6.3.1.1.1.2.1.6.4]
b. 1770 d. 20 Jul 1841
10
Casey Wood
[1.6.3.1.1.1.2.1.6.5]
b. 1772
10
Elizabeth Wood
[1.6.3.1.1.1.2.1.6.6]
b. 1780
10
Thomas Wood
[1.6.3.1.1.1.2.1.6.7]
b. 1782 d. 1820
9
Thomas Wood
[1.6.3.1.1.1.2.1.7]
b. 1740
9
Robert Wood
[1.6.3.1.1.1.2.1.8]
b. 1741
8
Mary Wood
[1.6.3.1.1.1.2.2]
b. 3 Nov 1712 d. 1 Aug 1727
8
John Wood
[1.6.3.1.1.1.2.3]
b. 4 Apr 1715 d. 11 Aug 1775
8
Ruth Wood
[1.6.3.1.1.1.2.4]
b. 24 Oct 1718
8
Martha Wood
[1.6.3.1.1.1.2.5]
b. 17 Feb 1722
8
Ephraim Wood
[1.6.3.1.1.1.2.6]
b. 18 Jun 1723 d. 1746
8
Dinah Wood
[1.6.3.1.1.1.2.7]
b. 17 Jun 1725
8
Nehemiah Wood
[1.6.3.1.1.1.2.8]
b. 16 Jan 1727 d. 1796
8
Jonathan Wood
[1.6.3.1.1.1.2.9]
b. 16 May 1730
7
Nehemiah Wood
[1.6.3.1.1.1.3]
b. 14 Jul 1688 d. 4 Aug 1688
7
Ephraim Wood
[1.6.3.1.1.1.4]
b. 13 Oct 1689 d. 26 Jun 1713
7
Samuel Wood
[1.6.3.1.1.1.5]
b. 31 May 1692 d. 25 Jul 1742
+
Jane Dudley
c. 1693
7
Elizabeth Wood
[1.6.3.1.1.1.6]
b. 8 Apr 1694 d. 23 Jul 1731
+
Philip Turner
7
Mehitable Wood
[1.6.3.1.1.1.7]
b. 18 Dec 1695 d. 26 Oct 1758
James Hall
b. 1693 d. 16 Jan 1742
8
Mary Hall
[1.6.3.1.1.1.7.1]
b. 27 Sep 1717 d. 1778
8
James Hall
[1.6.3.1.1.1.7.2]
b. 20 Apr 1720 d. 2 Feb 1807
8
Mehetable Hall
[1.6.3.1.1.1.7.3]
b. 18 Feb 1722 d. 7 Dec 1803
8
Elizabeth Hall
[1.6.3.1.1.1.7.4]
b. 18 Apr 1723
8
Jane Hall
[1.6.3.1.1.1.7.5]
b. 5 Mar 1725
8
William Hall
[1.6.3.1.1.1.7.6]
b. 12 Jul 1728
8
Thomas Hall
[1.6.3.1.1.1.7.7]
b. 14 Jun 1730
8
Ephraim Hall
[1.6.3.1.1.1.7.8]
b. 21 Sep 1732 d. 29 Sep 1816
8
Gershom Hall
[1.6.3.1.1.1.7.9]
b. 25 Feb 1735
8
Josiah Hall
[1.6.3.1.1.1.7.10]
b. 27 Mar 1738 d. 1810
7
Ann Wood
[1.6.3.1.1.1.8]
b. 11 Apr 1700 d. 30 Jul 1793
Isaac Sargent
b. Abt 24 Feb 1695 d. 12 Apr 1742
8
John Sargent
[1.6.3.1.1.1.8.1]
b. 6 Mar 1722 d. Dec 1827
8
Mary Sargent
[1.6.3.1.1.1.8.2]
b. 22 Apr 1725 d. 12 Dec 1740
8
Ana Sargent
[1.6.3.1.1.1.8.3]
b. 23 Feb 1727 d. 8 May 1821
8
Isaac Sargent
[1.6.3.1.1.1.8.4]
b. 30 Dec 1728 d. 17 Dec 1729
8
Hannah Sargent
[1.6.3.1.1.1.8.5]
b. 3 Dec 1730 d. 14 Aug 1751
8
Ruth Sargent
[1.6.3.1.1.1.8.6]
b. 14 Oct 1732 d. 29 Aug 1808
8
Elizabeth Sargent
[1.6.3.1.1.1.8.7]
b. 5 Feb 1734 d. 28 Dec 1776
8
Deborah Sargent
[1.6.3.1.1.1.8.8]
b. 2 Feb 1736 d. 1833
8
Isaac Sargent
[1.6.3.1.1.1.8.9]
b. 8 Dec 1737 d. Jan 1813
7
Hannah Wood
[1.6.3.1.1.1.9]
b. 21 May 1703 d. 18 Mar 1764
6
John Hunt
[1.6.3.1.1.2]
b. 1667 d. 10 Jun 1669
6
Nehemiah Hunt
[1.6.3.1.1.3]
b. 29 Sep 1669 d. 27 Oct 1718
6
John Hunt
[1.6.3.1.1.4]
b. 12 Jan 1673 d. 26 Dec 1751
6
William Hunt
[1.6.3.1.1.5]
b. 1 Nov 1678 d. 12 May 1755
6
Mercy Hunt
[1.6.3.1.1.6]
b. 29 Nov 1676 d. 28 Nov 1733
6
Hannah Hunt
[1.6.3.1.1.7]
b. 24 Jan 1681 d. 2 Aug 1736
6
Simon Hunt
[1.6.3.1.1.8]
b. 7 Mar 1682 d. 7 Oct 1702
6
Rebecca Hunt
[1.6.3.1.1.9]
b. 1686 d. 28 Nov 1733
6
Elizabeth Hunt
[1.6.3.1.1.10]
b. 3 Jun 1687 d. 13 Jul 1767
5
Samuel Hunt
[1.6.3.1.2]
b. 1633 d. 1707
Elizabeth Redding
b. 1634 d. 16 Feb 1706
6
Samuel Hunt
[1.6.3.1.2.1]
b. 17 Nov 1657 d. 11 Jan 1742
Ruth Todd
b. 11 Feb 1657 d. 18 Feb 1716
7
Samuel Hunt
[1.6.3.1.2.1.1]
b. 4 Feb 1678 d. 13 Oct 1738
Sarah Stearns
b. 21 Mar 1681 d. 10 Sep 1708
8
Sarah Hunt
[1.6.3.1.2.1.1.1]
b. 22 Oct 1702 d. 26 Jan 1750
8
Mary Hunt
[1.6.3.1.2.1.1.2]
b. 12 Jan 1705 d. 11 May 1796
Anne Haseltine
b. 4 Aug 1677 d. 16 Jul 1757
8
Thomas Hunt
[1.6.3.1.2.1.1.3]
b. 2 Aug 1710 d. Nov 1710
8
Samuel Hunt
[1.6.3.1.2.1.1.4]
b. 26 Sep 1711 d. Jan 1806
Hannah Kimball
b. 14 Apr 1723 d. 25 May 1776
9
Samuel Hunt
[1.6.3.1.2.1.1.4.1]
b. 19 Dec 1741 d. 1 Apr 1742
9
Samuel Hunt
[1.6.3.1.2.1.1.4.2]
b. 20 Sep 1743 d. 29 Apr 1766
9
Hannah Hunt
[1.6.3.1.2.1.1.4.3]
b. 3 Jan 1746 d. 9 Dec 1749
9
Johathan Hunt
[1.6.3.1.2.1.1.4.4]
b. 2 Jul 1750
9
Martha Hunt
[1.6.3.1.2.1.1.4.5]
b. 2 Apr 1758 d. 15 Feb 1825
9
Ebenezer Hunt
[1.6.3.1.2.1.1.4.6]
b. 18 Apr 1760 d. 30 Sep 1776
9
Perley Hunt
[1.6.3.1.2.1.1.4.7]
b. 23 Nov 1762 d. 21 Jun 1828
Persis Gleason
b. Sep 1766 d. 27 May 1835
10
Ebenezer
[1.6.3.1.2.1.1.4.7.1]
b. 23 Jun 1785 d. 24 Nov 1817
10
Elijah Hunt
[1.6.3.1.2.1.1.4.7.2]
b. 25 Apr 1787 d. 7 Sep 1860
Amanda Marsh
b. 14 Jul 1791 d. Aft 1850
11
Jason Hunt
[1.6.3.1.2.1.1.4.7.2.1]
b. 25 Apr 1811 d. 21 Oct 1888
11
Elijah Hunt, Jr
[1.6.3.1.2.1.1.4.7.2.2]
b. 1818
11
Ebenezer T Hunt
[1.6.3.1.2.1.1.4.7.2.3]
b. 1820 d. 24 Jul 1898
11
Jane Hunt
[1.6.3.1.2.1.1.4.7.2.4]
b. 1824
11
Samuel Russell Hunt
[1.6.3.1.2.1.1.4.7.2.5]
b. 22 Oct 1827 d. 14 May 1912
Mary Frances Hardy
b. 26 Oct 1832 d. 24 Apr 1899
12
Willy S Hunt
[1.6.3.1.2.1.1.4.7.2.5.1]
b. 1858
12
Edwin W Hunt
[1.6.3.1.2.1.1.4.7.2.5.2]
b. 1860
12
Roswin Hunt
[1.6.3.1.2.1.1.4.7.2.5.3]
b. 1863
12
George Washington Hunt
[1.6.3.1.2.1.1.4.7.2.5.4]
b. 26 Jun 1864 d. 5 Jul 1944 [
=>
]
12
May Hunt
[1.6.3.1.2.1.1.4.7.2.5.5]
b. 1868
12
Ernest O Hunt
[1.6.3.1.2.1.1.4.7.2.5.6]
b. Sep 1870
12
Lulu G Hunt
[1.6.3.1.2.1.1.4.7.2.5.7]
b. 1874
11
Jackson Hunt
[1.6.3.1.2.1.1.4.7.2.6]
b. 1834
10
Anna Hunt
[1.6.3.1.2.1.1.4.7.3]
b. 15 Feb 1788 d. 18 Dec 1791
10
Persis Hunt
[1.6.3.1.2.1.1.4.7.4]
b. 20 May 1790
10
Amy Hunt
[1.6.3.1.2.1.1.4.7.5]
b. 1 Jul 1793 d. 26 Jul 1793
10
Perley Hunt
[1.6.3.1.2.1.1.4.7.6]
b. 5 Nov 1795 d. 18 Nov 1863
10
Kimball Hunt
[1.6.3.1.2.1.1.4.7.7]
b. 18 Feb 1797 d. Oct 1821
10
Anna Hunt
[1.6.3.1.2.1.1.4.7.8]
b. 20 Jun 1800
10
Samuel Hunt
[1.6.3.1.2.1.1.4.7.9]
b. 14 Jan 1803 d. 30 Sep 1846
10
Gratia Hunt
[1.6.3.1.2.1.1.4.7.10]
b. 25 Jun 1805 d. 20 Nov 1872
10
Charles Dickenson Hunt
[1.6.3.1.2.1.1.4.7.11]
b. 31 Jul 1807 d. Aft 1855
10
Fidelia Hunt
[1.6.3.1.2.1.1.4.7.12]
b. 1 Oct 1809 d. 25 Jan 1826
9
David Hunt
[1.6.3.1.2.1.1.4.8]
b. 3 Jun 1767 d. 4 Feb 1850
8
Ann Hunt
[1.6.3.1.2.1.1.5]
b. 8 Apr 1714 d. 1740
8
Mehitable Hunt
[1.6.3.1.2.1.1.6]
b. 9 Jul 1716 d. 3 Mar 1807
8
Susanna Hunt
[1.6.3.1.2.1.1.7]
b. 21 Feb 1717
8
David Hunt
[1.6.3.1.2.1.1.8]
b. 19 Nov 1719
8
Jonathan Hunt
[1.6.3.1.2.1.1.9]
b. 25 Feb 1722
7
John Hunt
[1.6.3.1.2.1.2]
b. 30 Dec 1680 d. 22 Jan 1740
7
Elizabeth Hunt
[1.6.3.1.2.1.3]
b. 4 Mar 1682 d. 13 Jul 1685
6
Elisabeth Hunt
[1.6.3.1.2.2]
b. 29 May 1661 d. 9 Jul 1689
Francis Palmer
b. 4 Dec 1657 d. 19 Apr 1733
7
Elizabeth Palmer
[1.6.3.1.2.2.1]
b. 20 Dec 1684 d. 17 Aug 1705
7
John Palmer
[1.6.3.1.2.2.2]
b. 21 Jun 1689 d. 20 May 1761
Mary Stickney
b. 1 Mar 1687 d. 2 Nov 1763
8
Elizabeth Palmer
[1.6.3.1.2.2.2.1]
b. 1 May 1710 d. 10 Jun 1782
8
Daniel Palmer
[1.6.3.1.2.2.2.2]
b. 31 Jul 1712 d. 1776
8
Jane Palmer
[1.6.3.1.2.2.2.3]
b. 24 Dec 1714 d. 2 Sep 1793
8
Mary Palmer
[1.6.3.1.2.2.2.4]
b. 1 Jun 1717 d. 2 Nov 1763
Moses Duty
b. 2 Sep 1700 d. 29 Dec 1763
9
Moses Duty
[1.6.3.1.2.2.2.4.1]
b. 9 Aug 1742 d. 27 May 1836
Ann Holland
b. 13 Dec 1730 d. 24 Jan 1782
10
Mehitabel Duty
[1.6.3.1.2.2.2.4.1.1]
b. 18 Jul 1762 d. 22 Mar 1826
10
Susa Duty
[1.6.3.1.2.2.2.4.1.2]
b. 9 Apr 1769
9
Mary Elizabeth Duty
[1.6.3.1.2.2.2.4.2]
b. 11 Oct 1743 d. 27 May 1836
Asael Smith
b. 7 Mar 1744 d. 31 Oct 1830
10
Jesse Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1]
b. 20 Apr 1768 d. 16 Mar 1793
Hannah Peabody
b. 1771 d. 28 Sep 1849
11
Benjamin Peabody Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.1]
b. 2 May 1793 d. 15 Jan 1850
Lois Crandall
b. 3 Nov 1799 d. 10 Mar 1882
12
Esther Ann Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.1.1]
b. 15 Oct 1823 d. 24 Dec 1900
12
Martha Wallace Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.1.2]
b. 14 Oct 1825 d. 22 May 1849
12
Edwin Wallace Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.1.3]
b. 13 Apr 1827 d. 1 Sep 1907
12
Henry Storrs Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.1.4]
b. 11 Mar 1829 d. 3 Dec 1852
12
Benjamin Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.1.5]
b. 28 Apr 1833 d. 28 May 1833
12
Peabody Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.1.6]
b. 28 Apr 1833 d. 28 May 1833
12
Adeline Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.1.7]
b. 6 May 1834 d. 20 Aug 1911
12
James Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.1.8]
b. 16 Mar 1836 d. 21 Jan 1840
12
Jane Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.1.9]
b. 16 Mar 1836 d. 18 May 1917
12
Lois Ann Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.1.10]
b. 6 Apr 1838 d. 10 Aug 1922
12
Adelia Clarissa Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.1.11]
b. 12 Jul 1841 d. 6 Apr 1908
11
Eliza Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.2]
b. 9 Mar 1795 d. 22 Jul 1870
Stoddard Hunt
b. 14 Feb 1780 d. 10 Dec 1855
12
Daniel Smith Hunt
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.2.1]
b. 10 Dec 1826 d. 19 Feb 1882
12
Esther Hunt
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.2.2]
b. 10 Apr 1828 d. 1915
12
Fanny Hunt
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.2.3]
b. 8 Sep 1829 d. 30 May 1852
12
Jesse Hunt
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.2.4]
b. 7 Apr 1831 d. 17 Apr 1871
12
Stephen Hunt
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.2.5]
b. 16 Nov 1833 d. 16 Nov 1922
12
Royal Hunt
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.2.6]
b. 22 May 1836 d. 23 Dec 1880
12
Eliza Hunt
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.2.7]
b. 1 Aug 1840 d. 27 Nov 1918
11
Ira Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.3]
b. 30 Jan 1797 d. 5 Mar 1874
Lucy Post
12
Harry Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.3.1]
b. 26 Jul 1824 d. 4 Apr 1906
12
Norman E. Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.3.2]
b. 24 Nov 1825 d. 19 May 1918
12
James M. Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.3.3]
b. 2 Aug 1827 d. 21 Oct 1902
12
Esther Harmon Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.3.4]
b. 19 Feb 1831 d. 24 Dec 1917
12
Hannah P. Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.3.5]
b. 25 Sep 1832 d. 7 Mar 1859
12
Eliza Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.3.6]
b. 27 Jun 1834 d. 15 Dec 1907
12
Jesse Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.3.7]
b. 30 Dec 1837 d. 31 Dec 1917
11
Harvey Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.4]
b. 1 Apr 1799 d. 20 Feb 1872
Betsey M Yurann
b. 1 Jan 1800 d. 12 Jan 1839
12
Charles Chandler Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.4.1]
b. 13 Feb 1827 d. 14 Feb 1870
12
Horace Buck Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.4.2]
b. 24 Aug 1828 d. 10 Jan 1904
12
Elizabeth Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.4.3]
b. 1829
12
Lucy E. Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.4.4]
b. 7 Apr 1830 d. 4 Apr 1842
12
Betsey M. Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.4.5]
b. 7 May 1832 d. 8 May 1832
12
James Renwick Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.4.6]
b. 5 Sep 1833 d. 4 Apr 1842
12
Jason Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.4.7]
b. 27 Jul 1835 d. 23 Mar 1881
12
William N Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.4.8]
b. 22 Oct 1838 d. 6 May 1911
Electa Jenne
b. 25 Nov 1822 d. 17 Nov 1870
12
Benjamin C
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.4.9]
b. 24 Jul 1854 d. 2 May 1872
12
Jane
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.4.10]
b. 30 Sep 1855 d. 18 Oct 1918
12
Friend Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.4.11]
b. 19 Aug 1858 d. 8 Feb 1936
12
Miranda Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.4.12]
b. 15 Feb 1860 d. 26 May 1934
12
King E. Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.4.13]
b. 19 Mar 1862 d. 12 Jun 1865
11
Harriet Tupper Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.5]
b. 8 Apr 1801 d. Apr 1879
+
Ezra Martindall
11
Stephen Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.6]
b. 2 May 1803 d. 16 Apr 1851
+
Hannah Miller Hunt
b. Abt 1805
11
Mary Polly Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.7]
b. 4 May 1805 d. 13 Jun 1870
+
Hiram Chapman
b. 8 Apr 1795 d. 1867
11
Catherine Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.8]
b. 13 Jul 1807 d. 2 May 1888
James Kelsey
b. 9 Jun 1801 d. 9 Sep 1883
12
Hannah Kelsey
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.8.1]
b. 2 Mar 1829 d. 20 Nov 1905
12
Amanda Kelsey
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.8.2]
b. 24 Oct 1830 d. 1 Jun 1914
12
Eleanor Amelia Kelsey
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.8.3]
b. 5 Jul 1832 d. 9 Sep 1900
12
James Edwin Kelsey
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.8.4]
b. 5 Jul 1832 d. 27 Oct 1910
12
Julius Marcellus Kelsey
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.8.5]
b. 21 Jul 1836 d. 3 Nov 1905
12
Royal Smith Kelsey
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.8.6]
b. 7 Jun 1839 d. 24 Sep 1865
12
Mark Kelsey
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.8.7]
b. 8 Aug 1843 d. 26 Nov 1877
11
Royal Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.9]
b. 2 Jul 1809 d. 1882
+
Happeelona Peck
11
Sarah B Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.1.10]
b. 16 Dec 1810 d. 2 Oct 1887
+
Henry Barnard
+
Christene Smith
10
Priscilla Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.2]
b. 21 Oct 1769 d. 17 Apr 1860
John Curtis Waller
11
Calvin C. Waller
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.2.1]
b. 6 Jun 1797 d. Jun 1864
11
Dolly Waller
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.2.2]
b. 16 Oct 1799 d. 20 Jun 1800
11
Marshall Waller
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.2.3]
b. 18 Mar 1801
11
Royal H Waller
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.2.4]
b. 29 Nov 1802 d. 29 Sep 1866
11
Dudley C Waller
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.2.5]
b. 29 Sep 1804 d. Abt 1868
+
Mrs Dudley C Waller
b. Abt 1806
11
Bushrod W Waller
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.2.6]
b. 18 Oct 1806
11
Silas Waller
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.2.7]
b. 1 Jan 1809 d. 2 Jun 1866
Marietta Smith
b. 1811
12
Francis Waller
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.2.7.1]
b. 9 Feb 1841 d. 27 Oct 1844
12
Ellen Waller
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.2.7.2]
b. 11 Sep 1845
12
Anna Buffington
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.2.7.3]
b. 17 Dec 1848 d. 22 Jan 1852
12
Lilla Waller
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.2.7.4]
b. 21 Dec 1851 d. 20 Jan 1929
11
Salley P Waller
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.2.8]
b. 31 Oct 1810 d. 15 Aug 1874
11
John J Waller
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.2.9]
b. 9 Sep 1812 d. 5 Nov 1812
+
Michael Smith
10
Joseph Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3]
b. 12 Jul 1771 d. 14 Sep 1840
Lucy Mack
b. 8 Jul 1775 d. 14 May 1856
11
Son Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.1]
b. 1797 d. 1797
11
Daughter Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.2]
b. 1797 d. 1797
11
Alvin Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.3]
b. 11 Feb 1798 d. 19 Nov 1823
11
Hyrum Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.4]
b. 9 Feb 1800 d. 27 Jun 1844
Jerusha Barden
b. 15 Feb 1805 d. 13 Oct 1837
12
Lovina Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.4.1]
b. 16 Sep 1827 d. 8 Oct 1876
12
Mary Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.4.2]
b. 27 Jun 1829 d. 29 May 1832
12
John Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.4.3]
b. 22 Sep 1832
12
Hyrum Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.4.4]
b. 27 Apr 1834 d. 21 Sep 1841
12
Jerusha Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.4.5]
b. 13 Jan 1836 d. 27 Jun 1912
12
Sarah Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.4.6]
b. 2 Oct 1837 d. 6 Nov 1876
Mary Fielding
b. 21 Jul 1801 d. 21 Sep 1852
12
Joseph Fielding Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.4.7]
b. 13 Nov 1838 d. 19 Nov 1918 [
=>
]
12
Martha Ann Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.4.8]
b. 14 May 1841 d. 19 Oct 1923 [
=>
]
+
Catherine Phillips
b. 1 Aug 1819 d. 26 Sep 1905
+
Mercy Rachel Fielding
b. 15 Jun 1807 d. 15 Sep 1893
11
Sophronia Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.5]
b. 17 May 1803 d. 28 Oct 1876
Calvin W Stoddard
b. 7 Sep 1801 d. 19 Nov 1836
12
Eunice Stoddard
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.5.1]
b. 22 Mar 1830 d. 24 Jun 1831
12
Mariah Stoddard
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.5.2]
b. 12 Apr 1832 d. 8 Oct 1896
+
William McCleary
b. 9 Oct 1793 d. Jun 1846
11
Samuel Harrison Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.6]
b. 13 Mar 1808 d. 30 Jul 1844
Mary Bailey
b. 20 Dec 1808 d. 25 Jan 1841
12
Susanna Bailey Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.6.1]
b. 27 Oct 1835 d. 14 Dec 1905
12
Mary Bailey Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.6.2]
b. 27 Mar 1837 d. 14 Oct 1916
12
Samuel Harrison Bailey Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.6.3]
b. 1 Aug 1838 d. 12 Jun 1914
12
Lucy Bailey Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.6.4]
b. 6 Jan 1841 d. Jan 1841
Levira Clark
b. 30 Jul 1815 d. 1 Jan 1893
12
Levira Annette Clark Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.6.5]
b. 29 Apr 1842 d. 18 Dec 1888
12
Lovisa Clark Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.6.6]
b. 28 Aug 1843 d. Dec 1843
12
Lucy Jane Clark Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.6.7]
b. 20 Aug 1844 d. 1844
11
Ephraim Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.7]
b. 13 Mar 1810 d. 24 Mar 1810
11
William B Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.8]
b. 13 Mar 1811 d. 13 Nov 1893
Carolina Amanda Grant
b. 22 Jan 1814 d. 22 May 1845
12
Mary Jane Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.8.1]
b. 7 Jan 1834 d. 21 Dec 1878
12
Caroline L Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.8.2]
b. Aug 1839 d. 9 Jan 1878
Roxie Ann Grant
b. 16 Mar 1825 d. 30 Mar 1900
12
Thalia Grant Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.8.3]
b. 21 Sep 1848 d. 27 Nov 1924
12
Hyrum Wallace Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.8.4]
b. 17 Aug 1850 d. 27 Jan 1935
Eliza Elise Jane Sanborn
b. 16 Apr 1827 d. 7 Mar 1889
12
William Enoch Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.8.5]
b. 23 Jul 1858 d. 13 Feb 1930
12
Edson Don Carlos Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.8.6]
b. 16 Sep 1862 d. 13 Feb 1939
12
Louise Mae "Loie " Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.8.7]
b. 8 May 1866 d. 10 May 1925
+
Rosella Goyette
b. 16 May 1830 d. 6 Apr 1923
11
Katherine Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.9]
b. 28 Jul 1813 d. 1 Feb 1900
Wilkins Jenkins Salisbury
b. 6 Jan 1809 d. 27 Nov 1853
12
Elizabeth Salisbury
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.9.1]
b. 9 Apr 1832 d. 15 Jul 1832
12
Lucy Salisbury
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.9.2]
b. 3 Oct 1834 d. 18 Oct 1892
12
Reverend Solomon Jenkins Salisbury
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.9.3]
b. 18 Sep 1835 d. 12 Jan 1927
12
Alvin Salisbury
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.9.4]
b. 7 Jun 1838 d. 21 Aug 1880
12
Reverend Don C. Salisbury
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.9.5]
b. 25 Oct 1840 d. 6 Apr 1919
12
Emma C Salisbury
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.9.6]
b. 25 Mar 1844 d. 10 Oct 1846
12
Lorin Ephraim Salisbury
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.9.7]
b. 4 May 1845 d. 18 Nov 1849
12
Frederick Vilian Salisbury
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.9.8]
b. 27 Jan 1850 d. 24 Feb 1934
+
Joseph Younger
b. 1805 d. 1900
11
Don Carlos Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.10]
b. 25 Mar 1816 d. 7 Aug 1841
Agnes Moultin Coolbrith
b. 11 Jul 1811 d. 26 Dec 1876
12
Agnes Charlotte Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.10.1]
b. 7 Aug 1836 d. 31 Jan 1873
12
Sophronia C. Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.10.2]
b. 22 Apr 1838 d. 3 Oct 1843
12
Josephine Donna "Ina Coolbrith" Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.10.3]
b. 10 Mar 1841 d. 29 Feb 1928 [
=>
]
11
Lucy Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.11]
b. 18 Jul 1821 d. 9 Dec 1882
Arthur Millikin
b. 9 May 1817 d. 23 Apr 1882
12
Don Carlos Smith Millikin
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.11.1]
b. 13 Oct 1843 d. 26 Nov 1932
12
Sarah M Millikin
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.11.2]
b. 13 Sep 1844 d. 23 Nov 1934
12
George William Dell Millikin
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.11.3]
b. 4 Mar 1848 d. 16 Jan 1913
12
Florence Arabella Millikin
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.11.4]
b. 23 May 1850 d. 21 Oct 1927
12
Julia Amelia Millikin
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.11.5]
b. 17 Jun 1853 d. 7 Jun 1888
12
Frances A. Millikin
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.11.6]
b. 26 Oct 1856 d. 14 Mar 1858
12
Charles Arthur Millikin
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.11.7]
b. 31 Aug 1858 d. 12 May 1884
12
Clara Irene Millikin
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.11.8]
b. 23 Aug 1861 d. 26 Mar 1948
12
Clarence Hyrum Millikin
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.11.9]
b. 26 Mar 1865 d. 5 Apr 1922
11
Joseph Smith, Jr
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.12]
b. 23 Dec 1805 d. 27 Jun 1844
Emma Hale
b. 10 Jul 1804 d. 30 Apr 1879
12
Alvin Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.12.1]
b. 15 Jun 1828 d. 15 Jun 1828
12
Joseph Murdock Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.12.2]
b. 30 Apr 1831 d. 29 Mar 1832
12
Julia Murdock Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.12.3]
b. 30 Apr 1831 d. 12 Sep 1880
12
Thaddeus Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.12.4]
b. 30 Apr 1831 d. 30 Apr 1831
12
Louisa Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.12.5]
b. 30 Apr 1831 d. 30 Apr 1831
12
Joseph Smith, III
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.12.6]
b. 6 Nov 1832 d. 10 Dec 1914 [
=>
]
12
Frederick Granger Williams Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.12.7]
b. 20 Jun 1836 d. 13 Apr 1862 [
=>
]
12
Alexander Hale Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.12.8]
b. 2 Jun 1838 d. 12 Aug 1909 [
=>
]
12
Don Carlos Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.12.9]
b. 13 Jun 1840 d. 15 Sep 1841
12
Thomas Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.12.10]
b. 6 Feb 1842 d. 6 Feb 1842
12
David Hyrum Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.3.12.11]
b. 17 Nov 1844 d. 29 Aug 1904 [
=>
]
+
Agnes Moultin Coolbrith
b. 11 Jul 1811 d. 26 Dec 1876
+
Fanny Young
b. 8 Nov 1787 d. 11 Jun 1859
+
Eliza Roxey Snow
b. 21 Jan 1804 d. 5 Dec 1887
+
Francis Ward "Fanny" Alger
b. 30 Sep 1817 d. 29 Nov 1889
+
Louisa Beaman
b. 7 Feb 1815 d. 15 May 1850
+
Helen Mar Kimball
b. 25 Aug 1828 bur. 15 Nov 1896
+
Emily Dow Partridge
b. 28 Feb 1824 d. 9 Dec 1899
+
Olive Grey Frost
b. 24 Jul 1816 d. 8 Oct 1845
+
Rhoda Richards
b. 8 Aug 1784 d. 17 Jan 1879
+
Lucy Walker
b. 30 Apr 1826 d. 1 Oct 1910
+
Sarah Ann Whitney
b. 22 Mar 1825 d. 4 Sep 1873
+
Prescinda Lothrop Huntington
b. 7 Sep 1810 d. 1 Feb 1892
+
Eliza Partridge
b. 20 Apr 1820 bur. 2 Mar 1886
+
Desdemona Wadsworth Fullmer
b. 6 Oct 1809 d. 9 Feb 1886
+
Zina Diantha Huntington
b. 31 Jan 1821 d. 28 Aug 1901
+
Mary Elizabeth Rollins
b. 9 Apr 1818 d. 17 Dec 1913
+
Martha McBride
b. 17 Mar 1805 d. 20 Nov 1901
+
Sylvia Porter Sessions
b. 31 Jul 1818 d. 12 Apr 1882
+
Patty Bartlett
b. 4 Feb 1795 d. 14 Dec 1892
+
Maria Lawrence
b. 18 Dec 1823 d. 1847
+
Sarah A Lawrence
b. 13 May 1826 d. 28 Nov 1872
10
Asahel Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4]
b. 21 May 1773 d. 21 Jul 1848
Elizabeth Shellenger
b. 1 Dec 1785 d. 14 Oct 1846
11
Elias Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.1]
b. 6 Sep 1804 d. 24 Jun 1888
Amy Jane King
b. 2 Oct 1836 d. 8 Nov 1913
12
Silas Thomas Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.1.1]
b. 4 May 1857 d. 1 May 1945
12
Jesse Moroni Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.1.2]
b. 21 Nov 1858 d. 14 Mar 1937
12
Rebecca Jane Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.1.3]
b. 23 Sep 1860 d. 18 Jul 1923
12
Mary Alzina Knapp Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.1.4]
b. 16 May 1865 d. 20 Jan 1953
12
Martha Priscilla Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.1.5]
b. 30 May 1865 d. 18 Apr 1946
12
Amy Esther Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.1.6]
b. 11 Aug 1867 d. 21 Sep 1910
12
Angelina Adelia Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.1.7]
b. 11 Jul 1869 d. 8 Mar 1950
12
Franklin Elias Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.1.8]
b. 13 Dec 1871 d. 24 Jul 1917
12
Sarah Susannah Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.1.9]
b. 26 Mar 1873 d. 25 Apr 1952
12
Hiram Bennett Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.1.10]
b. 2 Feb 1877 d. 29 Mar 1951
Lucy Brown
b. 4 Jan 1821 d. 3 Apr 1896
12
Emily Jane Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.1.11]
b. 28 Oct 1850 d. 8 May 1878 [
=>
]
12
Lucy Elizabeth Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.1.12]
b. 24 Jan 1855 d. 3 Jun 1944
12
Elias Asahel Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.1.13]
b. 31 Mar 1857 d. 6 Dec 1942
12
Edith Ann Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.1.14]
b. 5 Aug 1861 d. 27 Jun 1954
11
Emily Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.2]
b. 1 Sep 1806 d. 11 Aug 1893
Samuel Pierce Hoyt
b. 21 Nov 1807 d. 12 Aug 1889
12
Cynthia Ann Hoyt
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.2.1]
b. Abt 1848
12
Hyrum Hoyt
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.2.2]
b. 1855
11
Jessie Johnson Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.3]
b. 6 Oct 1808 d. 1 Jul 1834
Sarah Ann Bennett
b. Abt 1808
12
Priscilla Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.3.1]
c. 26 Jul 1840
11
Esther Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.4]
b. 20 Sep 1810 d. 31 Oct 1856
Amos Botsford Fuller
b. 26 Mar 1810 d. 29 Mar 1853
12
Son Fuller
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.4.1]
b. 15 May 1833 d. 15 May 1833
12
Daughter Fuller
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.4.2]
b. 3 Apr 1834 d. 8 Apr 1834
12
Jesse Johnson Fuller
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.4.3]
b. 1 Jun 1835 d. 31 May 1906
12
Mary Adelia Fuller
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.4.4]
b. 31 Aug 1838 d. 5 Jan 1916
12
Luburn Livonia Fuller
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.4.5]
b. 19 Dec 1840 d. 30 Oct 1887
12
Sophina Alcesta Fuller
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.4.6]
b. 5 May 1843 d. 26 Dec 1930 [
=>
]
12
Amos Botsford Fuller
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.4.7]
b. 28 Sep 1846 d. 18 Aug 1879
12
Esther Victoria Fuller
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.4.8]
b. 13 Jan 1848 d. 4 Sep 1857
11
Mary Jane Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.5]
b. 29 Apr 1815 d. 1 Mar 1878
George Washington Gee
b. 13 Aug 1815 d. 20 Jan 1842
12
Elias Smith Gee
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.5.1]
b. 30 May 1838 d. 10 Aug 1855
12
George Washington Gee, Jr
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.5.2]
b. 9 Oct 1841 d. 17 Sep 1919 [
=>
]
11
Julia Priscilla Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.6]
b. 4 Mar 1815 d. 14 Aug 1906
Moses Martin
b. 1 Jun 1812 d. 5 May 1899
12
Julia Priscilla Martin
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.6.1]
b. 1 Aug 1838 d. 14 Jan 1873
12
Napoleon J Martin
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.6.2]
b. 1841
12
Rosella A Martin
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.6.3]
b. 18 Aug 1844 d. 13 Sep 1909
12
Hiram Martin
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.6.4]
b. 1 Aug 1847 d. Sep 1882
12
Joseph Martin
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.6.5]
b. Abt 1850
12
Emma Cecelia Martin
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.6.6]
b. Aug 1850 d. Jul 1882
12
Ada Martin
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.6.7]
b. 1854
11
Silas Schellinger Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.7]
b. 6 Jun 1822 d. 11 Jun 1892
Elizabeth Orton
b. 1 Jun 1826 d. 27 Nov 1902
12
Silas Marion Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.7.1]
b. 17 Apr 1845 d. 20 Oct 1898
12
Julia Elizabeth Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.7.2]
b. 29 Jul 1848 d. 28 Oct 1878 [
=>
]
12
Frederick Asael Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.7.3]
b. 24 Jan 1850 d. 1850
12
Mary Jane Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.7.4]
b. 17 Jun 1853 d. 5 Jan 1917 [
=>
]
12
Prince Henry Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.7.5]
b. 20 Oct 1858 d. 28 Nov 1922
12
Franklin D Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.7.6]
b. 29 Dec 1862 d. 16 Nov 1924
12
Vienna Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.7.7]
b. 16 Jun 1864 d. 17 Aug 1874
12
Martha Eliza Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.7.8]
b. 8 Oct 1869 d. 19 Jul 1956
Sarah Orton
b. 12 May 1830 d. 11 Dec 1912
12
Prince William Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.7.9]
b. 2 Aug 1859 d. 16 Nov 1909
12
Alexander Randolph Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.7.10]
b. 23 Dec 1861 d. 10 Sep 1865
12
David Hyrum Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.7.11]
b. 23 Dec 1863 d. 11 Mar 1865
12
Elias Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.7.12]
b. 16 May 1867 d. 18 Sep 1942
12
Sarah Esther Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.7.13]
b. 4 Nov 1869 d. 7 Nov 1869
12
Alonzo Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.7.14]
b. 5 Apr 1871 d. 24 Jan 1916 [
=>
]
11
Martha Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.8]
b. 9 Jun 1817 d. 12 Oct 1902
Hiram Bell Bennett
b. 1 Mar 1823 d. 17 Aug 1912
12
Henry Bell Bennett
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.8.1]
b. Jun 1846 d. Jun 1846
12
Hyrum William Asahel Bennett
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.8.2]
b. 22 Nov 1848 d. 9 Jan 1849
12
Martha Eliza Bennett
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.8.3]
b. 24 Jan 1849 d. 6 May 1924 [
=>
]
12
Ezra Melanthorn Bennett
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.8.4]
b. 20 Oct 1851 d. 25 Aug 1852
12
Emily Jane Bennett
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.8.5]
b. 17 Jan 1854 d. 4 May 1903 [
=>
]
12
Elizabeth Emma Bennett
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.8.6]
b. 2 Jul 1856 d. 26 Feb 1940 [
=>
]
12
Elias Austin Bennett
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.4.8.7]
b. 26 Jan 1858 d. 1 May 1861
+
Jane Smith
b. 1775
10
Mary Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.5]
b. 4 Jun 1775 d. 24 May 1844
Isaac Pierce
b. 11 Oct 1773 d. 9 Nov 1847
11
Eunice Pierce
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.5.1]
b. 29 Apr 1799 d. 9 Jun 1803
11
Laura Pierce
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.5.2]
b. 12 Nov 1801 d. 1803
11
Miranda Pierce
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.5.3]
b. 17 Jun 1803 d. 16 Sep 1831
11
Horace Pierce
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.5.4]
b. 8 Jun 1805 d. 20 May 1877
11
John S. Pierce
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.5.5]
b. 6 Jun 1807 d. 3 Apr 1854
11
Susan Pierce
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.5.6]
b. 20 Jun 1809 d. 4 Apr 1855
11
Mary Pierce
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.5.7]
b. 25 Apr 1811
11
Elisabeth Ann Pierce
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.5.8]
b. 2 Sep 1817 d. 16 May 1855
+
Joseph Brimhall
b. 1771
+
Charles Smith
b. 1772
10
Samuel Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.6]
b. 15 Sep 1777 d. 1 Apr 1830
Frances Wilcox
b. 1780
11
Charles Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.6.1]
b. 16 Apr 1817
11
Laura Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.6.2]
b. 1 Mar 1819
11
Horace Jay Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.6.3]
b. 12 Jul 1821
11
Sarah Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.6.4]
b. 11 Jun 1824
11
Elizabeth Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.6.5]
b. 16 Jul 1826
10
Silas Sanford Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7]
b. 1 Oct 1779 d. 13 Sep 1839
Ruth Steven
b. 1782 d. 10 Jan 1864
11
Charles Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.1]
b. 11 Nov 1806 d. 7 May 1809
11
Charity Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.2]
b. 1 Apr 1808 d. 2 Jun 1888
+
Richard Smith
b. 1808
11
Curtis Stevens Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.3]
b. 29 Oct 1809 d. 23 Sep 1861
Celia Euphrasia Ross
b. 1829 d. 28 Jun 1857
12
Ezra Ross Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.3.1]
b. 24 Jul 1852 d. 17 May 1853
12
William Curtis Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.3.2]
b. 14 Apr 1857 d. 1 Mar 1945
11
Samuel Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.4]
b. 3 Oct 1811 d. 7 Mar 1826
11
Stephen Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.5]
b. 8 Jan 1815 d. 20 Feb 1891
11
Susan Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.6]
b. 19 Oct 1817 d. 20 Nov 1846
11
Asahel Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.7]
b. 12 Oct 1819 d. 15 May 1834
Mary Aikens
b. 13 Aug 1797 d. 27 Apr 1877
11
Silas Sanford Smith, Jr
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.8]
b. 26 Oct 1830 d. 11 Oct 1910
Martha Eliza Bennett
b. 24 Jan 1849 d. 6 May 1924
12
Sarah Ann Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.8.1]
b. 11 Jul 1868 d. 2 Feb 1900
12
Martha Eliza Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.8.2]
b. 17 Mar 1870 d. 7 Jan 1957 [
=>
]
12
Curtis Bennett Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.8.3]
b. 23 Oct 1871 d. 28 Nov 1942
12
Elias Austin Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.8.4]
b. 4 Mar 1874 d. 27 Jun 1925 [
=>
]
12
Emma Jane Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.8.5]
b. 4 Apr 1876 d. 16 Jan 1951 [
=>
]
12
George Essex Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.8.6]
b. 24 Sep 1878 d. 26 May 1949 [
=>
]
12
Erastus Snow Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.8.7]
b. 18 Aug 1881 d. 16 Sep 1890
12
Hyrum Asahel Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.8.8]
b. 15 Sep 1883 d. 16 Jul 1941 [
=>
]
12
Lucy Edith Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.8.9]
b. 12 Aug 1886 d. 6 Jan 1963 [
=>
]
12
Joseph Frances Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.8.10]
b. 7 Apr 1889 d. 14 Feb 1920 [
=>
]
12
Clara Estella Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.8.11]
b. 4 Aug 1891 d. 10 May 1992
12
Verlie Dorcas Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.8.12]
b. 14 Oct 1894 d. 23 Dec 1894
Clarinda Rich
b. 10 Jan 1835 d. 18 Mar 1864
12
Silas Sanford Smith, Jr
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.8.13]
b. 10 Jul 1853 d. 19 Jan 1911
12
Jesse Joel Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.8.14]
b. 4 Nov 1857 d. 12 Sep 1905
12
Leonora Abigail Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.8.15]
b. 22 Oct 1859 d. 26 Sep 1863
12
Stephen Augustus Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.8.16]
b. 1 Nov 1861 d. 21 Oct 1939
12
Ella Clarinda Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.8.17]
b. 9 Mar 1864 d. 2 Jun 1913
Sally Ann Ricks
b. 28 Dec 1832 d. 30 Jun 1864
12
John Aikens Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.8.18]
b. 19 Mar 1854 d. 9 Jan 1923 [
=>
]
12
Mary Eleanor Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.8.19]
b. 26 Sep 1857 d. 25 Nov 1888
12
Hortense Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.8.20]
b. 14 Oct 1859 d. 8 Sep 1945
12
Albert Ricks Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.8.21]
b. 1 Apr 1862 d. 17 May 1905
12
Hyrum Barton Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.8.22]
b. 16 Jun 1864 d. 9 Aug 1864
11
John Aikens Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.9]
b. 6 Jul 1832 d. 27 Nov 1838
11
Jesse Nathaniel Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.10]
b. 2 Dec 1834 d. 5 Jun 1906
Augusta Maria Outzen
b. 14 Jan 1854 d. 26 Apr 1932
12
Georgianna Bathsheba Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.10.1]
b. 16 Aug 1870 d. 14 May 1946
12
Augusta Gerhardina "Dina" Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.10.2]
b. 14 Jul 1872 d. 9 Jan 1940
12
Robert Christian Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.10.3]
b. 27 Nov 1874 d. 9 Apr 1920
12
Martha Amelia Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.10.4]
b. 17 Jul 1877 d. 10 Aug 1931 [
=>
]
12
Asahel Henry Smith, Sr
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.10.5]
b. 5 Dec 1880 d. 7 Sep 1947
12
Anna Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.10.6]
b. 6 Aug 1883 d. 8 Oct 1910
12
Rebecca Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.10.7]
b. 23 Oct 1886 d. 3 Nov 1960
12
Rachel Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.10.8]
b. 1 Jan 1889 d. 13 Jul 1940
12
Sophronia Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.10.9]
b. 8 Apr 1892 d. 11 Oct 1953
12
Natalia Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.10.10]
b. 3 Apr 1894 d. 2 Jun 1978
12
Millie Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.10.11]
b. 25 Dec 1897 d. 3 Oct 1931
Emma Seraphine West
b. 3 Jan 1836 d. 15 Oct 1910
12
Emma Seraphine Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.10.12]
b. 12 Aug 1853 d. 29 Dec 1909
12
Mary Josephine Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.10.13]
b. 23 Jan 1855 d. 17 Dec 1894
12
Hannah Daphne Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.10.14]
b. 22 Mar 1857 d. 10 May 1937
12
Eliza Snow Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.10.15]
b. 23 Feb 1859 d. 27 Dec 1927
12
Jesse Nathaniel Smith, Jr
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.10.16]
b. 16 May 1861 d. 13 Jul 1912
12
Sarah Elizabeth Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.10.17]
b. 2 Feb 1866 d. 15 Sep 1892
12
Silas Derryfield Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.10.18]
b. 9 Sep 1867 d. 26 Feb 1956
12
John Walter Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.10.19]
b. 10 Jun 1871 d. 7 May 1936
12
Samuel Francis Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.10.20]
b. 21 Nov 1873 d. 24 Jan 1954
Margaret Fletcher West
b. 22 May 1838 d. 1 Feb 1864
12
Adelaide Margaret Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.10.21]
b. 13 Feb 1857 d. 29 Oct 1927
12
Joseph West Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.10.22]
b. 6 Sep 1859 d. 22 Dec 1944
Janet Mauretta Johnson
b. 17 Dec 1848 d. 21 May 1933
12
Susan Janet Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.10.23]
b. 15 Sep 1868 d. 15 Dec 1960 [
=>
]
12
Ellen Mauretta Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.10.24]
b. 20 Sep 1871 d. 1 Aug 1872
12
Sariah Anna Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.10.25]
b. 21 Feb 1873 d. 26 Dec 1922
12
Agnes Maud Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.10.26]
b. 11 Jul 1874 d. 7 Oct 1878
12
Julia Johnson Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.10.27]
b. 20 Oct 1875 d. 27 Apr 1956
12
Priscilla Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.10.28]
b. 10 May 1877 d. 17 Jan 1954
12
Editha Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.10.29]
b. 8 Sep 1878 d. 28 Jul 1931
12
Lucy Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.10.30]
b. 24 Jun 1880 d. 15 Nov 1951 [
=>
]
12
Margaret Fife Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.10.31]
b. 6 Sep 1882 d. 28 Mar 1969
12
Ruth Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.10.32]
b. 17 Mar 1884 d. 31 Dec 1956
12
Esther Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.10.33]
b. 26 Oct 1887 d. 8 Dec 1975
12
Elias Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.10.34]
b. 1 Aug 1889 d. 23 Dec 1961
12
Leah Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.10.35]
b. 13 Aug 1891 d. 17 Feb 1976
Emma Ellen Larson
b. 6 Apr 1863 d. 2 Jun 1943
12
Hyrum Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.10.36]
b. 15 Dec 1882 d. 22 Mar 1971
12
Caroline Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.10.37]
b. 19 Nov 1884 d. 19 Jan 1924
12
Don Carlos Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.10.38]
b. 26 Sep 1886 d. 28 Oct 1967
12
Lorana Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.10.39]
b. 29 Nov 1888 d. 25 Apr 1979
12
Lehi Larson Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.10.40]
b. 19 Mar 1891 d. 28 Oct 1918
12
George Albert Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.10.41]
b. 7 May 1893 d. 31 Jan 1965
12
Aikens Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.10.42]
b. 29 Jul 1899 d. 17 Jul 1960
12
Myrtle Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.10.43]
b. 25 Oct 1901 d. 10 Jan 1977
12
Matthias Foss Cowley Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.7.10.44]
b. 1 Oct 1905 d. 5 Feb 1990
10
Patriarch John Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.8]
b. 16 Jul 1781 d. 23 May 1854
Clarissa Loomis Lyman
b. 27 Jun 1790 d. 14 Feb 1854
11
Daughter Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.8.1]
b. 9 May 1816 d. 9 May 1816
11
George Albert Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.8.2]
b. 26 Jun 1817 d. 1 Sep 1875
Bathsheba Wilson Bigler
b. 3 May 1822 d. 20 Sep 1910
12
George Albert Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.8.2.1]
b. 7 Jul 1842 bur. 8 Jan 1876
12
Son Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.8.2.2]
b. Abt 1844
12
Bathsheba Kate Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.8.2.3]
b. 14 Aug 1844 d. 22 Dec 1920
12
Daughter Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.8.2.4]
b. Abt 1846
12
John Henry Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.8.2.5]
b. 4 Apr 1847 d. 4 Apr 1847
Nancy A Clement
b. 31 Oct 1815 d. 26 Mar 1847
12
Lydia Crane
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.8.2.6]
b. 1800 d. Oct 1827
12
Nancy Alida Crane
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.8.2.7]
b. 20 Mar 1807 d. Dec 1882
12
Nancy Adelia Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.8.2.8]
b. 20 Mar 1846 d. 17 Apr 1847
12
Ellen Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.8.2.9]
b. Dec 1846 d. Apr 1847
Lucy Messerve Smith
b. 9 Feb 1817 d. 5 Oct 1892
12
Don Carlos Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.8.2.10]
b. 11 Aug 1846 d. 21 Jul 1847
12
Joel Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.8.2.11]
b. 6 Aug 1850 d. 6 Aug 1850
Zilpha Stark
b. 3 Jul 1818 d. 19 Sep 1887
12
Zilpha Adelade Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.8.2.12]
b. 12 Mar 1846 d. 12 May 1846
12
Joseph Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.8.2.13]
b. 2 Jan 1850 d. 8 Oct 1850
12
Mary Amelia Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.8.2.14]
b. 14 Feb 1852 d. 20 Mar 1915
Sarah Ann Libby
b. 7 May 1818 d. 12 Jun 1851
12
John Henry Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.8.2.15]
b. 18 Sep 1848 d. 13 Oct 1911 [
=>
]
Hannah Maria Libby
b. 29 Jun 1828 d. 21 Sep 1906
12
Charles Warren Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.8.2.16]
b. 16 Jan 1849 d. 25 Jan 1903
12
Sarah Maria Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.8.2.17]
b. 1 Jan 1856 d. 16 Jan 1912
12
Eunice Albertine Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.8.2.18]
b. 6 Mar 1860 d. 4 Oct 1861
12
George Albert Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.8.2.19]
b. 7 Apr 1862 d. 28 Oct 1863
12
Grace Libby Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.8.2.20]
b. 14 May 1865 d. 27 Feb 1939
Susan Elizabeth West
b. 4 Dec 1833 d. 6 Jul 1935
12
Clarissa West Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.8.2.21]
b. 21 Apr 1859 d. 8 Mar 1930
12
Margaret West Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.8.2.22]
b. 6 Dec 1862 d. 18 Jun 1913
12
Elizabeth Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.8.2.23]
b. 28 Sep 1866 d. 6 Jan 1921
12
Priscilla Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.8.2.24]
b. 11 Jun 1869 d. 3 Nov 1907
12
Emma Pearl Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.8.2.25]
b. 19 Apr 1871 d. 6 Oct 1905
11
Caroline Clara Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.8.3]
b. 6 Jun 1820 d. 8 Jan 1895
Thomas Callister
b. 8 Jul 1821 d. 1 Dec 1880
12
Thomas Callister
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.8.3.1]
b. 13 Sep 1846 d. 8 May 1847
12
Clarissa Callister
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.8.3.2]
b. 28 May 1848 d. 4 Oct 1848
12
Clara Caroline Callister
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.8.3.3]
b. 18 Apr 1850 d. 22 Sep 1892
12
Philomela Callister
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.8.3.4]
b. 11 Jul 1851 d. 22 Feb 1879
12
Mary Maranda Callister
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.8.3.5]
b. 17 Aug 1853 d. 14 May 1930
12
Samuel Jay Callister
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.8.3.6]
b. 14 Jan 1856 d. 14 Jan 1856
12
Bathsheba Smith Callister
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.8.3.7]
b. 21 Sep 1860 d. 1 Nov 1860
11
John Lyman Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.8.4]
b. 17 Nov 1828 d. 21 Feb 1898
10
Susannah Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.9]
b. 18 May 1783 d. 22 Mar 1849
+
John Hall
10
Stephen Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.10]
b. 23 Apr 1785 d. 25 Jul 1802
+
Sally Hadley
10
Sarah Smith
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.11]
b. 16 May 1789 d. 27 May 1824
Joseph Sanford
b. 1785 d. 11 Sep 1825
11
Martin Sanford
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.11.1]
b. 24 Sep 1811 d. 24 Nov 1817
11
Martin Sanford
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.11.2]
b. 4 Nov 1812 d. 3 Dec 1820
11
Joseph Sanford
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.11.3]
b. 1813 d. 1816
11
Charlette Sanford
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.11.4]
b. 4 Mar 1814 d. Abt 1858
11
William Wallace Sanford
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.11.5]
b. 13 Jun 1816 d. 1844
11
John Lyman Sanford
[1.6.3.1.2.2.2.4.2.11.6]
b. 20 May 1818
9
Eunice Duty
[1.6.3.1.2.2.2.4.3]
b. 20 Jun 1745 d. 27 May 1836
9
Mark Duty
[1.6.3.1.2.2.2.4.4]
b. 16 Oct 1747 d. 27 May 1836
Abigail Woodberry
b. 1 Apr 1746 d. 1774
10
Andrew Woodbarry Duty
[1.6.3.1.2.2.2.4.4.1]
b. 18 Jul 1772 d. 1823
10
Hannah Duty
[1.6.3.1.2.2.2.4.4.2]
b. 14 Dec 1773
10
Mark Duty
[1.6.3.1.2.2.2.4.4.3]
b. 16 Jun 1779 d. Abt 1855
10
Ebenezer Duty
[1.6.3.1.2.2.2.4.4.4]
b. 2 Jun 1782 d. 7 Sep 1852
9
William Duty
[1.6.3.1.2.2.2.4.5]
b. 9 Jan 1749 d. 27 Sep 1812
Mary Rowell
b. 29 Apr 1750 d. 27 May 1836
10
Mary Duty
[1.6.3.1.2.2.2.4.5.1]
b. 7 Nov 1774
10
Phebe Dutey
[1.6.3.1.2.2.2.4.5.2]
b. 4 Apr 1778 d. 16 Apr 1852
10
Abagail Duty
[1.6.3.1.2.2.2.4.5.3]
b. 4 Dec 1779
10
William Duty
[1.6.3.1.2.2.2.4.5.4]
b. 4 Jun 1781
10
Hannah Duty
[1.6.3.1.2.2.2.4.5.5]
b. 13 May 1783 d. Oct 1787
10
Charles Carpenter Duty
[1.6.3.1.2.2.2.4.5.6]
b. 12 Feb 1785
10
Benjamin Rowell Duty
[1.6.3.1.2.2.2.4.5.7]
b. 15 Aug 1787
10
Nathaniel Peabody Duty
[1.6.3.1.2.2.2.4.5.8]
b. 11 Aug 1789
9
Elizabeth Duty
[1.6.3.1.2.2.2.4.6]
b. 26 Oct 1751
9
Sarah Duty
[1.6.3.1.2.2.2.4.7]
b. 25 Jul 1753 d. 21 Dec 1767
9
Hannah Duty
[1.6.3.1.2.2.2.4.8]
b. 11 Jun 1755 d. 27 May 1836
William Rowell
b. 1749 d. 30 Mar 1844
10
Sarah Rowell
[1.6.3.1.2.2.2.4.8.1]
b. 4 Jul 1777
10
Moses Duty Rowell
[1.6.3.1.2.2.2.4.8.2]
b. 5 Oct 1778 d. 16 Nov 1857
10
John Sullivan Rowell
[1.6.3.1.2.2.2.4.8.3]
b. 1779 d. Abt 1824
10
Lavina Rowell
[1.6.3.1.2.2.2.4.8.4]
b. 1782 d. 11 Jan 1877
10
Elsie Alice Rowell
[1.6.3.1.2.2.2.4.8.5]
b. Abt 1786
10
Caleb Rowell
[1.6.3.1.2.2.2.4.8.6]
b. Abt 1788 d. 5 Apr 1835
10
Isaiah Rowell
[1.6.3.1.2.2.2.4.8.7]
b. Abt 1792 d. 25 Jun 1847
10
George Rowell
[1.6.3.1.2.2.2.4.8.8]
b. 16 Oct 1794 d. 21 Jan 1873
8
Hannah Palmer
[1.6.3.1.2.2.2.5]
b. 30 Sep 1719 d. 9 Mar 1792
Gideon Walker
b. 1715
9
Temperance Walker
[1.6.3.1.2.2.2.5.1]
b. Abt 1739
9
Eliphalet Walker
[1.6.3.1.2.2.2.5.2]
b. 3 Sep 1747 d. 28 Mar 1824
9
Mehitable Walker
[1.6.3.1.2.2.2.5.3]
b. Abt 1749
8
Mehitable Palmer
[1.6.3.1.2.2.2.6]
b. 18 Mar 1727 d. Bef Nov 1763
8
John Palmer
[1.6.3.1.2.2.2.7]
b. 30 Nov 1729 d. 6 Jan 1807
6
William Hunt
[1.6.3.1.2.3]
b. 23 Apr 1663 d. 12 Dec 1747
6
Joseph Hunt
[1.6.3.1.2.4]
b. 28 Oct 1665 d. 1757
6
Peter Hunt
[1.6.3.1.2.5]
b. 8 Aug 1668 d. 8 Mar 1669
5
Elizabeth Hunt
[1.6.3.1.3]
b. 1 Apr 1634 d. 18 Aug 1704
John Barron
b. 1635 d. 1 Jan 1693
6
Isaac Barron
[1.6.3.1.3.1]
b. Abt 1664
6
John Barron
[1.6.3.1.3.2]
b. 4 Apr 1665
6
Elizabeth Barron
[1.6.3.1.3.3]
b. 28 Sep 1667
6
Moses Barron
[1.6.3.1.3.4]
b. 26 Mar 1669 d. 1742
6
Elias Barron
[1.6.3.1.3.5]
b. 14 Jun 1672 d. 1725
6
Dorothy Barron
[1.6.3.1.3.6]
b. 6 Mar 1675
5
Ann Hunt
[1.6.3.1.4]
b. 17 May 1635 d. 29 Dec 1714
Thomas Wood
b. 7 Apr 1633 d. 21 Jul 1687
6
Mary Wood
[1.6.3.1.4.1]
b. 15 Mar 1654
James Chute
b. 1649 d. 1730
7
Mary Chute
[1.6.3.1.4.1.1]
b. 16 Sep 1674 d. 10 Sep 1750
7
Elisabeth Chute
[1.6.3.1.4.1.2]
b. 22 Jun 1676 d. 3 Apr 1761
7
Ann Chute
[1.6.3.1.4.1.3]
b. 9 Oct 1679 d. 1726
7
Lionel Chute
[1.6.3.1.4.1.4]
b. 15 Apr 1681 d. Aft 30 Apr 1730
7
James Chute
[1.6.3.1.4.1.5]
b. 14 Jun 1686 d. 31 Jan 1769
7
Thomas Chute
[1.6.3.1.4.1.6]
b. 30 Jan 1690 d. 1770
7
Martha Chute
[1.6.3.1.4.1.7]
b. 15 Feb 1693 d. 4 Jul 1777
7
Ruth Chute
[1.6.3.1.4.1.8]
b. 2 Nov 1695 d. 30 Apr 1776
7
Hannah Chute
[1.6.3.1.4.1.9]
b. 8 Jul 1700 d. 1787
6
John Wood
[1.6.3.1.4.2]
b. 2 Mar 1656 d. 24 Jun 1735
Isabella Hazen
b. 21 May 1662 d. 24 Jul 1735
7
Hannah Wood
[1.6.3.1.4.2.1]
b. 12 Jan 1681 d. 3 Mar 1733
7
John Wood
[1.6.3.1.4.2.2]
b. 13 Feb 1683 d. 13 Feb 1735
7
Priscillia Wood
[1.6.3.1.4.2.3]
b. 27 Aug 1686 d. 22 May 1721
7
Edward Wood
[1.6.3.1.4.2.4]
b. 7 Sep 1689 d. Bef 1704
7
Thomas Wood
[1.6.3.1.4.2.5]
b. 28 Nov 1691 d. 1764
7
Samuel Wood
[1.6.3.1.4.2.6]
b. 31 May 1692 d. 25 Jul 1742
7
Joseph Wood
[1.6.3.1.4.2.7]
b. 5 May 1696 d. 7 Feb 1766
7
Ebenezer Wood
[1.6.3.1.4.2.8]
b. 18 Sep 1698 d. 18 Jul 1744
7
Abigail Annie Wood
[1.6.3.1.4.2.9]
b. 17 Dec 1700 d. 4 Apr 1776
7
Richard Wood
[1.6.3.1.4.2.10]
b. 30 Jan 1706 d. 3 Jul 1761
7
Josiah Wood
[1.6.3.1.4.2.11]
b. 5 Apr 1708 d. Nov 1767
6
Thomas Wood
[1.6.3.1.4.3]
b. 10 Aug 1658 d. 1 Dec 1702
Mary Hunt
b. 28 Sep 1664 d. 1 Dec 1702
7
Mary Wood
[1.6.3.1.4.3.1]
b. 29 Aug 1684 d. 12 Dec 1774
Daniel Pearson
b. 25 Dec 1684 d. 8 Jun 1759
8
Simon Pearson
[1.6.3.1.4.3.1.1]
b. 7 Nov 1709
Ruth Taylor
b. 3 Apr 1712
9
Ruth Pearson
[1.6.3.1.4.3.1.1.1]
b. 21 Oct 1739
9
Benjamin Person
[1.6.3.1.4.3.1.1.2]
b. 21 May 1742
9
Ezra Pearson
[1.6.3.1.4.3.1.1.3]
b. 16 Apr 1744 d. 30 Dec 1800
Anne Fuller
b. 1741 d. Aft 1810
10
Lucinda Pearson
[1.6.3.1.4.3.1.1.3.1]
b. 29 Jan 1767
+
Ezekiel Barton
b. Abt 1767
10
Lieutenant Adin Pearson
[1.6.3.1.4.3.1.1.3.2]
b. 28 Nov 1768 d. 7 Jun 1853
Eunice Brooks
b. 3 Oct 1771 d. 24 Nov 1801
11
Lucina Pearson
[1.6.3.1.4.3.1.1.3.2.1]
b. 16 Jul 1789 d. 6 Sep 1878
Jonathan Harvey Andrus
b. 18 Feb 1783 d. 18 Jan 1875
12
Orrin Clark Andrus
[1.6.3.1.4.3.1.1.3.2.1.1]
b. 9 Dec 1807 d. 19 May 1885 [
=>
]
12
Pamelia Andrus
[1.6.3.1.4.3.1.1.3.2.1.2]
b. 21 Oct 1809 d. 14 Sep 1877 [
=>
]
12
Adeline Brooks Andrus
[1.6.3.1.4.3.1.1.3.2.1.3]
b. 18 Mar 1813 d. 20 Apr 1898 [
=>
]
12
Walter Harvey Andrus
[1.6.3.1.4.3.1.1.3.2.1.4]
b. 3 Feb 1815 d. 24 Jan 1898
12
Lucina Andrus
[1.6.3.1.4.3.1.1.3.2.1.5]
b. 24 Jul 1817 d. 27 Mar 1891 [
=>
]
12
Adin Parsons Andrus
[1.6.3.1.4.3.1.1.3.2.1.6]
b. 27 Aug 1820 d. 4 Nov 1899
12
Harriet Warner Andrus
[1.6.3.1.4.3.1.1.3.2.1.7]
b. 26 Sep 1824 d. 17 Mar 1890
12
Annie Marie Andrus
[1.6.3.1.4.3.1.1.3.2.1.8]
b. 25 Oct 1827 d. 14 Feb 1881
12
Caroline Adelia Andrus
[1.6.3.1.4.3.1.1.3.2.1.9]
b. 6 Feb 1830 d. 18 Aug 1904
11
Warren Pearson
[1.6.3.1.4.3.1.1.3.2.2]
b. 23 Jul 1792
11
Loren Pearson
[1.6.3.1.4.3.1.1.3.2.3]
b. 5 Oct 1797 d. 19 Jul 1861
10
Zelotes Pearson
[1.6.3.1.4.3.1.1.3.3]
b. 9 Sep 1771
+
Anna
b. Abt 1771
10
Clarice Pearson
[1.6.3.1.4.3.1.1.3.4]
b. 11 Feb 1774
+
John Little
b. Abt 1774
10
Jerusha Pearson
[1.6.3.1.4.3.1.1.3.5]
b. 15 Aug 1776 d. 9 Feb 1874
+
Gates Willey
b. Abt 1776
10
Anna Pearson
[1.6.3.1.4.3.1.1.3.6]
b. 2 Feb 1779 d. 26 Jan 1830
Elam Wright
b. 1 Dec 1774 d. 6 Feb 1831
11
Elam G Wright
[1.6.3.1.4.3.1.1.3.6.1]
b. 10 Feb 1811
11
Alvira Lucretia Wright
[1.6.3.1.4.3.1.1.3.6.2]
b. 17 Aug 1815
11
Vienna Wright
[1.6.3.1.4.3.1.1.3.6.3]
b. 28 Oct 1817 d. 29 Nov 1909
8
Ephraim Pearson
[1.6.3.1.4.3.1.2]
c. 25 Nov 1711
James Dickinson
b. 30 Jun 1678 d. 5 Jan 1705
8
Mary Dickinson
[1.6.3.1.4.3.1.3]
b. 29 Nov 1703 d. 8 Jun 1759
8
James Dickinson
[1.6.3.1.4.3.1.4]
b. 31 Dec 1705 d. 27 Jun 1756
Ruth Hartshorn
b. 12 May 1706 d. Aft 1750
9
Mary Dickinson
[1.6.3.1.4.3.1.4.1]
b. 20 Feb 1728
9
Submit Dickinson
[1.6.3.1.4.3.1.4.2]
b. 29 Jun 1731 d. 1788
9
Ruth Dickson
[1.6.3.1.4.3.1.4.3]
b. 3 Mar 1734
9
James Dickinson
[1.6.3.1.4.3.1.4.4]
b. 1 Aug 1736 d. Aft 1775
9
Jonathan Dickinson
[1.6.3.1.4.3.1.4.5]
b. 18 Nov 1738 d. 16 Oct 1762
Abigail Whipple
b. 30 Jan 1729 d. 21 Apr 1806
10
Mary Dickinson
[1.6.3.1.4.3.1.4.5.1]
b. 25 Dec 1758 d. 5 Mar 1759
10
Jonathan Dickinson
[1.6.3.1.4.3.1.4.5.2]
b. 30 Sep 1760
10
Mary Dickinson
[1.6.3.1.4.3.1.4.5.3]
b. Mar 1762 d. May 1850
9
Noah Dickinson
[1.6.3.1.4.3.1.4.6]
b. 14 Mar 1741 d. 16 Jan 1828
9
Mathew Dickinson
[1.6.3.1.4.3.1.4.7]
b. 14 Apr 1743 d. 21 Sep 1762
9
Ruth Dickinson
[1.6.3.1.4.3.1.4.8]
b. 29 Jul 1745 d. 22 Nov 1834
9
Love Dickinson
[1.6.3.1.4.3.1.4.9]
b. 2 Jun 1750
7
Thomas Wood
[1.6.3.1.4.3.2]
b. 18 Sep 1686 d. 27 Sep 1760
Abigail Hartshorn
b. 29 Sep 1686 d. 22 Sep 1760
8
Thomas Wood
[1.6.3.1.4.3.2.1]
b. 5 Feb 1711 d. 1777
Mary Lashley
b. 25 Mar 1711 d. Abt Dec 1809
9
John Wood
[1.6.3.1.4.3.2.1.1]
b. 13 Sep 1733
9
Elizabeth Wood
[1.6.3.1.4.3.2.1.2]
b. 20 Jul 1735 d. 1795
9
Johannah Wood
[1.6.3.1.4.3.2.1.3]
b. 22 Jun 1737 d. 3 Jun 1805
9
Alice Wood
[1.6.3.1.4.3.2.1.4]
b. 1738
9
Elijah Wood
[1.6.3.1.4.3.2.1.5]
b. 1739 d. Feb 1805
9
Lashley Levi Wood
[1.6.3.1.4.3.2.1.6]
b. 1740 d. 15 Aug 1809
Mary Mersey Lucas
b. Jan 1740 d. 1809
10
Mary Wood
[1.6.3.1.4.3.2.1.6.1]
c. 8 Apr 1764 d. 1840
John W Ogden
b. 1763 d. Apr 1824
11
Sarah Ogden
[1.6.3.1.4.3.2.1.6.1.1]
b. 1784
11
John W Ogden
[1.6.3.1.4.3.2.1.6.1.2]
b. 1786 d. 1830
11
Joseph Ogden
[1.6.3.1.4.3.2.1.6.1.3]
b. 1788 d. 1 Nov 1854
11
Otho W Ogden
[1.6.3.1.4.3.2.1.6.1.4]
b. 1792 d. 5 Apr 1816
Susannah Hansbrough
b. 31 Mar 1799 d. 4 Nov 1850
12
Susan Hansborough Ogden
[1.6.3.1.4.3.2.1.6.1.4.1]
b. 10 Oct 1820 d. 21 Nov 1902 [
=>
]
11
James Ogden
[1.6.3.1.4.3.2.1.6.1.5]
b. 29 Nov 1792 d. 24 Aug 1852
11
Thomas Ogden
[1.6.3.1.4.3.2.1.6.1.6]
b. Abt 1796 d. Bef 25 Jul 1845
11
Elias Ogden
[1.6.3.1.4.3.2.1.6.1.7]
b. 1798 d. 1847
11
Polly Ogden
[1.6.3.1.4.3.2.1.6.1.8]
b. 1800
10
Leatha Ann Wood
[1.6.3.1.4.3.2.1.6.2]
b. 10 Aug 1766 d. 1831
10
John Wood
[1.6.3.1.4.3.2.1.6.3]
b. 10 Aug 1768 d. 15 Sep 1853
10
Basil Wood
[1.6.3.1.4.3.2.1.6.4]
b. 1770 d. 20 Jul 1841
10
Casey Wood
[1.6.3.1.4.3.2.1.6.5]
b. 1772
10
Elizabeth Wood
[1.6.3.1.4.3.2.1.6.6]
b. 1780
10
Thomas Wood
[1.6.3.1.4.3.2.1.6.7]
b. 1782 d. 1820
9
Thomas Wood
[1.6.3.1.4.3.2.1.7]
b. 1740
9
Robert Wood
[1.6.3.1.4.3.2.1.8]
b. 1741
8
Mary Wood
[1.6.3.1.4.3.2.2]
b. 3 Nov 1712 d. 1 Aug 1727
8
John Wood
[1.6.3.1.4.3.2.3]
b. 4 Apr 1715 d. 11 Aug 1775
8
Ruth Wood
[1.6.3.1.4.3.2.4]
b. 24 Oct 1718
8
Martha Wood
[1.6.3.1.4.3.2.5]
b. 17 Feb 1722
8
Ephraim Wood
[1.6.3.1.4.3.2.6]
b. 18 Jun 1723 d. 1746
8
Dinah Wood
[1.6.3.1.4.3.2.7]
b. 17 Jun 1725
8
Nehemiah Wood
[1.6.3.1.4.3.2.8]
b. 16 Jan 1727 d. 1796
8
Jonathan Wood
[1.6.3.1.4.3.2.9]
b. 16 May 1730
7
Nehemiah Wood
[1.6.3.1.4.3.3]
b. 14 Jul 1688 d. 4 Aug 1688
7
Ephraim Wood
[1.6.3.1.4.3.4]
b. 13 Oct 1689 d. 26 Jun 1713
7
Samuel Wood
[1.6.3.1.4.3.5]
b. 31 May 1692 d. 25 Jul 1742
+
Jane Dudley
c. 1693
7
Elizabeth Wood
[1.6.3.1.4.3.6]
b. 8 Apr 1694 d. 23 Jul 1731
+
Philip Turner
7
Mehitable Wood
[1.6.3.1.4.3.7]
b. 18 Dec 1695 d. 26 Oct 1758
James Hall
b. 1693 d. 16 Jan 1742
8
Mary Hall
[1.6.3.1.4.3.7.1]
b. 27 Sep 1717 d. 1778
8
James Hall
[1.6.3.1.4.3.7.2]
b. 20 Apr 1720 d. 2 Feb 1807
8
Mehetable Hall
[1.6.3.1.4.3.7.3]
b. 18 Feb 1722 d. 7 Dec 1803
8
Elizabeth Hall
[1.6.3.1.4.3.7.4]
b. 18 Apr 1723
8
Jane Hall
[1.6.3.1.4.3.7.5]
b. 5 Mar 1725
8
William Hall
[1.6.3.1.4.3.7.6]
b. 12 Jul 1728
8
Thomas Hall
[1.6.3.1.4.3.7.7]
b. 14 Jun 1730
8
Ephraim Hall
[1.6.3.1.4.3.7.8]
b. 21 Sep 1732 d. 29 Sep 1816
8
Gershom Hall
[1.6.3.1.4.3.7.9]
b. 25 Feb 1735
8
Josiah Hall
[1.6.3.1.4.3.7.10]
b. 27 Mar 1738 d. 1810
7
Ann Wood
[1.6.3.1.4.3.8]
b. 11 Apr 1700 d. 30 Jul 1793
Isaac Sargent
b. Abt 24 Feb 1695 d. 12 Apr 1742
8
John Sargent
[1.6.3.1.4.3.8.1]
b. 6 Mar 1722 d. Dec 1827
8
Mary Sargent
[1.6.3.1.4.3.8.2]
b. 22 Apr 1725 d. 12 Dec 1740
8
Ana Sargent
[1.6.3.1.4.3.8.3]
b. 23 Feb 1727 d. 8 May 1821
8
Isaac Sargent
[1.6.3.1.4.3.8.4]
b. 30 Dec 1728 d. 17 Dec 1729
8
Hannah Sargent
[1.6.3.1.4.3.8.5]
b. 3 Dec 1730 d. 14 Aug 1751
8
Ruth Sargent
[1.6.3.1.4.3.8.6]
b. 14 Oct 1732 d. 29 Aug 1808
8
Elizabeth Sargent
[1.6.3.1.4.3.8.7]
b. 5 Feb 1734 d. 28 Dec 1776
8
Deborah Sargent
[1.6.3.1.4.3.8.8]
b. 2 Feb 1736 d. 1833
8
Isaac Sargent
[1.6.3.1.4.3.8.9]
b. 8 Dec 1737 d. Jan 1813
7
Hannah Wood
[1.6.3.1.4.3.9]
b. 21 May 1703 d. 18 Mar 1764
6
Ann Wood
[1.6.3.1.4.4]
b. 8 Aug 1660 d. 31 Jan 1715
Benjamin Plummer
b. 23 Oct 1656 d. 8 Jul 1724
7
John Plumer
[1.6.3.1.4.4.1]
b. 7 May 1680 d. 16 Apr 1706
7
Benjamin Plummer, Jr
[1.6.3.1.4.4.2]
b. 2 Mar 1681 d. 22 Jun 1734
7
Thomas Plummer
[1.6.3.1.4.4.3]
b. 15 Apr 1684 d. 15 Nov 1762
Ruth Pearson
b. 2 Aug 1687 d. 16 Nov 1736
8
Samuel Plumer
[1.6.3.1.4.4.3.1]
b. Abt 1726 d. 18 Jul 1807
8
Thomas Plumer
[1.6.3.1.4.4.3.2]
b. 1714 d. 12 Mar 1770
8
Ruth Plumer
[1.6.3.1.4.4.3.3]
b. 5 Feb 1721 d. 24 Jun 1736
8
Mehitabel Plumer
[1.6.3.1.4.4.3.4]
b. Bef 1712 d. Bef 27 Feb 1714
8
Stephen Plummer
[1.6.3.1.4.4.3.5]
b. 20 Feb 1716 d. Bef 1737
7
Sarah Plumer
[1.6.3.1.4.4.4]
b. 6 Aug 1686 d. Aft 1708
7
Stephen Palmer
[1.6.3.1.4.4.5]
b. 1 Sep 1688
7
Ann Plumer
[1.6.3.1.4.4.6]
b. 18 Jan 1690 d. 28 Jun 1748
7
Mary Plummer
[1.6.3.1.4.4.7]
b. 28 Jul 1694 d. 28 Jun 1748
7
Martha Plummer
[1.6.3.1.4.4.8]
b. 2 Mar 1696 d. 6 Aug 1733
7
Nathan Plummer
[1.6.3.1.4.4.9]
b. 26 Feb 1701 d. 1775
6
Ruth Wood
[1.6.3.1.4.5]
b. 21 May 1662 d. 29 Oct 1734
Joseph Jewett
b. 1 Apr 1656 d. 30 Oct 1694
7
Ruth Jewett
[1.6.3.1.4.5.1]
b. 1681 d. 28 Nov 1728
7
Joshua Jewett
[1.6.3.1.4.5.2]
b. 26 Aug 1683 d. 15 Oct 1694
7
Hannah Jewett
[1.6.3.1.4.5.3]
b. 3 Apr 1685 d. 23 Nov 1685
7
Elizabeth Jewett
[1.6.3.1.4.5.4]
b. 3 Apr 1685
7
Joseph Jewett
[1.6.3.1.4.5.5]
b. 10 Apr 1687 d. 10 Aug 1747
7
Sarah Jewett
[1.6.3.1.4.5.6]
b. 3 Feb 1689 d. 20 Nov 1722
7
Priscilla Jewett
[1.6.3.1.4.5.7]
b. 1 Feb 1690 d. 27 Dec 1722
Hilkiah Boynton
b. 19 Nov 1687 d. 16 Nov 1745
8
Joanna Boynton
[1.6.3.1.4.5.7.1]
b. 17 Aug 1712 d. Aft 7 Aug 1753
John Grout
b. 14 Oct 1704 d. Jun 1771
9
Johanna Grout
[1.6.3.1.4.5.7.1.1]
b. 8 Jan 1728/1729
9
Hilkiah Grout
[1.6.3.1.4.5.7.1.2]
b. 23 Jul 1728 d. 12 Dec 1795
9
John Grout, Jr
[1.6.3.1.4.5.7.1.3]
b. 13 Jun 1731 d. Aft 1779
Phebe Spofford
b. 1 Jul 1733
10
Phebe Grout
[1.6.3.1.4.5.7.1.3.1]
b. 21 Mar 1751 d. 1819
Jacob Winn
b. 20 Oct 1744
11
Augustus Winn
[1.6.3.1.4.5.7.1.3.1.1]
b. 18 Dec 1769 d. 24 Jun 1785
11
Lucend Winn
[1.6.3.1.4.5.7.1.3.1.2]
b. 12 Mar 1771
11
Phebe Winn
[1.6.3.1.4.5.7.1.3.1.3]
b. 7 Feb 1773 d. 23 May 1809
11
Endymia Winn
[1.6.3.1.4.5.7.1.3.1.4]
b. 1775 d. 1794
Thomas Sherwood
b. 1757 d. Abt 1844
12
Lucinda Sherwood
[1.6.3.1.4.5.7.1.3.1.4.1]
b. 13 Oct 1794 d. 7 Apr 1854 [
=>
]
12
Thomas Sherwood
[1.6.3.1.4.5.7.1.3.1.4.2]
b. 1797 d. 1865
10
Elijah Grout
[1.6.3.1.4.5.7.1.3.2]
b. 26 Jan 1753
10
Susannah Grout
[1.6.3.1.4.5.7.1.3.3]
b. 12 Dec 1754
10
Endymia Grout
[1.6.3.1.4.5.7.1.3.4]
b. 23 Dec 1756 d. 24 Apr 1759
10
Theodore Grout
[1.6.3.1.4.5.7.1.3.5]
b. 23 Aug 1759
10
Endymia Grout
[1.6.3.1.4.5.7.1.3.6]
b. 5 Aug 1761
10
John Butler Grout
[1.6.3.1.4.5.7.1.3.7]
b. 28 Apr 1763
10
Ferdinand Grout
[1.6.3.1.4.5.7.1.3.8]
b. 5 May 1765
10
Theodore Grout
[1.6.3.1.4.5.7.1.3.9]
b. 1 Feb 1767 d. 1831
10
Frederica Grout
[1.6.3.1.4.5.7.1.3.10]
b. 1 Dec 1768
10
Margaret Bradstreet Grout
[1.6.3.1.4.5.7.1.3.11]
b. 10 Apr 1771
9
Elijah Grout
[1.6.3.1.4.5.7.1.4]
b. 29 Oct 1732 d. Mar 1807
9
Joel Grout
[1.6.3.1.4.5.7.1.5]
b. 6 Mar 1734 d. 8 Sep 1797
9
Jonathan Grout
[1.6.3.1.4.5.7.1.6]
b. 23 Jul 1737 d. 8 Sep 1807
9
Sarah Grout
[1.6.3.1.4.5.7.1.7]
b. 28 Nov 1738 d. 21 Oct 1817
9
Patience Grout
[1.6.3.1.4.5.7.1.8]
b. 23 Aug 1740 d. 7 May 1810
9
Peter Grout
[1.6.3.1.4.5.7.1.9]
b. 9 Oct 1743
9
Abigail Grout
[1.6.3.1.4.5.7.1.10]
b. 23 Mar 1745 d. 14 Sep 1838
9
Josiah Grout
[1.6.3.1.4.5.7.1.11]
b. 28 Nov 1748 d. Bef 8 Jan 1777
9
Solomon Grout
[1.6.3.1.4.5.7.1.12]
b. 27 Jun 1751 d. 1787
9
Jehosaphat Grout
[1.6.3.1.4.5.7.1.13]
b. 7 Aug 1753 d. 6 Sep 1806
8
Priscilla Boynton
[1.6.3.1.4.5.7.2]
b. 11 Apr 1714 d. 1 Jan 1781
8
Hilikia Boynton
[1.6.3.1.4.5.7.3]
b. 11 Apr 1714 d. 28 Apr 1714
8
Joseph Boynton
[1.6.3.1.4.5.7.4]
b. 4 Dec 1717 d. 8 Feb 1718
8
Sarah Boynton
[1.6.3.1.4.5.7.5]
b. Abt 1718
8
Ruth Boynton
[1.6.3.1.4.5.7.6]
b. 1721 d. Jul 1721
8
Jane Boynton
[1.6.3.1.4.5.7.7]
b. 4 Mar 1722 d. 1743
7
Johanna Jewett
[1.6.3.1.4.5.8]
b. 12 Apr 1693 d. 26 Jul 1748
7
Joshua Jewett
[1.6.3.1.4.5.9]
b. 16 Feb 1695 d. 31 Oct 1760
6
Elizabeth Wood
[1.6.3.1.4.6]
b. 5 Sep 1664 d. Aft 1680
+
Captain Joseph Boynton
b. 13 May 1644 d. 16 Dec 1730
6
Josiah Wood
[1.6.3.1.4.7]
b. 5 Sep 1664 d. 10 Dec 1728
Mary Felt
b. Abt 1661 d. 4 Aug 1753
7
Samuel Wood
[1.6.3.1.4.7.1]
b. 4 Nov 1691
7
Sarah Wood
[1.6.3.1.4.7.2]
b. 15 Feb 1693 d. 10 Nov 1782
7
James Wood
[1.6.3.1.4.7.3]
b. 9 Apr 1695
7
Mary Wood
[1.6.3.1.4.7.4]
b. 28 Jan 1698 d. 3 Mar 1776
7
Josiah Wood
[1.6.3.1.4.7.5]
b. 14 Mar 1701 d. 7 Nov 1763
7
Ruth Wood
[1.6.3.1.4.7.6]
b. 4 Jun 1704
7
Elizabeth Wood
[1.6.3.1.4.7.7]
b. 26 May 1706 d. 1775
7
George Wood
[1.6.3.1.4.7.8]
b. 13 Aug 1708 d. Abt 1773
7
Anne Wood
[1.6.3.1.4.7.9]
b. 21 Dec 1710 d. 12 Nov 1783
7
Daniel David Wood
[1.6.3.1.4.7.10]
b. 13 Mar 1714 d. 16 May 1783
6
Samuel Wood
[1.6.3.1.4.8]
b. 26 Dec 1666 d. 25 Nov 1690
Margaret Elithorpe
b. 24 Jul 1672 d. 25 Jan 1754
7
Thomas Wood
[1.6.3.1.4.8.1]
b. 4 Mar 1689
6
Ebenezer Wood
[1.6.3.1.4.9]
b. 7 May 1669 d. 16 Feb 1737
+
Johanna Gage
b. Abt 1668 d. Aft 1737
6
Solomon Wood
[1.6.3.1.4.10]
b. 17 May 1669 d. 13 Jan 1752
6
James Wood
[1.6.3.1.4.11]
b. 22 Jun 1674 d. 18 Oct 1694
5
William Hunt
[1.6.3.1.5]
b. Abt 1635 d. 6 Sep 1694
5
Hannah Ann Hunt
[1.6.3.1.6]
b. 14 Feb 1640 d. 25 May 1721
Daniel White
b. Abt 1649 d. 6 May 1724
6
Joseph White
[1.6.3.1.6.1]
b. 17 Dec 1662 d. 28 Oct 1757
Susanna Sherman
b. Abt 1678 d. 22 Dec 1766
7
Hannah White
[1.6.3.1.6.1.1]
b. 28 Mar 1702 d. 29 Jul 1775
7
Abijah White
[1.6.3.1.6.1.2]
b. 8 Oct 1706 d. 20 Oct 1775
Anna Little
b. 30 Jan 1715 d. 11 Mar 1791
8
Anna White
[1.6.3.1.6.1.2.1]
b. 1739 d. Bef 1829
8
Persilla White
[1.6.3.1.6.1.2.2]
b. 1740 d. Bef 1830
8
Sylvanus White
[1.6.3.1.6.1.2.3]
b. 1742
8
Abijah White
[1.6.3.1.6.1.2.4]
b. 1745 d. 8 Feb 1746
8
Deborah White
[1.6.3.1.6.1.2.5]
b. 20 Aug 1746 d. 19 Oct 1746
8
Abijah White
[1.6.3.1.6.1.2.6]
b. 1747 d. 1777
8
Sarah White
[1.6.3.1.6.1.2.7]
b. 29 Mar 1749 d. Bef 1839
8
William White
[1.6.3.1.6.1.2.8]
b. Abt 1752 d. 19 Dec 1817
8
John White
[1.6.3.1.6.1.2.9]
b. 9 Sep 1753 d. 1 Feb 1774
8
Susanna White
[1.6.3.1.6.1.2.10]
b. 1756 d. 10 Apr 1793
8
Anna White
[1.6.3.1.6.1.2.11]
b. 27 Oct 1759
8
Persilla White
[1.6.3.1.6.1.2.12]
b. 17 Oct 1760
7
Cornelius White
[1.6.3.1.6.1.3]
b. 29 Jan 1711 d. 8 Nov 1800
Hannah Riggs
b. Abt 1670 d. Aft 1752
8
Prudence White
[1.6.3.1.6.1.3.1]
b. Abt 1741
8
Mose White
[1.6.3.1.6.1.3.2]
b. 2 Aug 1743 d. 6 Mar 1829
8
Sarah White
[1.6.3.1.6.1.3.3]
b. Abt 1748 d. Bef 1848
8
Mary White
[1.6.3.1.6.1.3.4]
b. Abt 1749 d. 10 Mar 1838
8
Hannah White
[1.6.3.1.6.1.3.5]
b. 1 Jan 1750
8
Asa White
[1.6.3.1.6.1.3.6]
b. 4 Aug 1752 d. 17 Jan 1822
7
Sarah White
[1.6.3.1.6.1.4]
b. 31 May 1710 d. 15 Feb 1788
Isaac Phillips
b. 5 Mar 1701 d. 18 Sep 1787
8
Isaac Phillips, Jr
[1.6.3.1.6.1.4.1]
b. 16 Dec 1728 d. 11 Jun 1831
8
David Phillips
[1.6.3.1.6.1.4.2]
b. 17 Aug 1731
8
Sarah Phillips
[1.6.3.1.6.1.4.3]
b. 4 Apr 1735 d. 26 Jul 1760
8
Anna Phillips
[1.6.3.1.6.1.4.4]
b. 15 Mar 1736 d. 19 Jan 1819
8
James Phillips
[1.6.3.1.6.1.4.5]
b. 30 Mar 1739
8
Rebekah Phillips
[1.6.3.1.6.1.4.6]
b. 21 Mar 1742
8
Joseph Phillips
[1.6.3.1.6.1.4.7]
b. 1 Dec 1749 d. 1751
8
Solomon Phillips
[1.6.3.1.6.1.4.8]
b. Dec 1750
7
Rebekah White
[1.6.3.1.6.1.5]
b. 17 Dec 1713 d. 1716
7
Sylvanus White
[1.6.3.1.6.1.6]
b. 24 Jul 1718 d. 19 Dec 1742
7
Jesse White
[1.6.3.1.6.1.7]
b. 7 Dec 1720 d. 1765
Catherina Charlotte Wilhelmina Subellina Warner
b. Abt 1720 d. Abt 1771
8
Sybelene White
[1.6.3.1.6.1.7.1]
b. 1744 d. May 1747
8
Sybelene White
[1.6.3.1.6.1.7.2]
b. 1748
8
Christiana White
[1.6.3.1.6.1.7.3]
b. 1750 d. 5 Aug 1818
Lydia Copeland
b. 27 Mar 1642 d. 8 May 1727
7
Mary White
[1.6.3.1.6.1.8]
b. 27 Feb 1682 d. 1701
7
Captain Joseph White
[1.6.3.1.6.1.9]
b. 19 Oct 1683 d. 15 Jun 1737
Prudence Smith
b. 19 Jul 1691 d. 5 Apr 1785
8
Joseph White
[1.6.3.1.6.1.9.1]
b. 22 Sep 1712 d. 12 Mar 1788
Judeth Clarke
b. 1711 d. 3 Feb 1794
9
Sarah White
[1.6.3.1.6.1.9.1.1]
b. 1735 d. 1747
9
Tryal White
[1.6.3.1.6.1.9.1.2]
b. 8 May 1737 d. 14 Jun 1814
Lieutenant Abner Taft
b. 28 Dec 1736 d. 30 May 1809
10
Oliver Taft
[1.6.3.1.6.1.9.1.2.1]
b. 1 May 1758 d. 16 Jul 1775
10
Moses Taft
[1.6.3.1.6.1.9.1.2.2]
b. 29 Sep 1760 d. 4 Dec 1848
Judith Cummings
b. 26 Nov 1766 d. 26 Nov 1816
11
Nancy Taft
[1.6.3.1.6.1.9.1.2.2.1]
b. 10 Mar 1787
11
Samuel Taft
[1.6.3.1.6.1.9.1.2.2.2]
b. 24 Sep 1790 d. 11 Oct 1863
11
Lucy Taft
[1.6.3.1.6.1.9.1.2.2.3]
b. 24 Apr 1795 d. 21 Jun 1847
11
Newell Taft
[1.6.3.1.6.1.9.1.2.2.4]
b. 28 Jul 1804 d. 4 Nov 1873
Hannah G Taft
b. 18 May 1802 d. 8 Jan 1843
12
Albert Taft
[1.6.3.1.6.1.9.1.2.2.4.1]
b. 28 Aug 1823 d. Aft 1874 [
=>
]
12
Marcy Taft
[1.6.3.1.6.1.9.1.2.2.4.2]
b. Mar 1829 d. 12 Apr 1830
12
Charles M Taft
[1.6.3.1.6.1.9.1.2.2.4.3]
b. Jan 1843 d. 7 Dec 1843
11
Sylvia Taft
[1.6.3.1.6.1.9.1.2.2.5]
b. 23 Aug 1810 d. 3 Aug 1816
10
Mary Taft
[1.6.3.1.6.1.9.1.2.3]
b. 12 Oct 1767 d. 18 Aug 1775
10
Webb Taft
[1.6.3.1.6.1.9.1.2.4]
b. 26 Mar 1772 d. 21 Apr 1842
Lucy Taft
b. 9 Jun 1774 d. 14 Mar 1846
11
Lucinda Taft
[1.6.3.1.6.1.9.1.2.4.1]
b. 22 Nov 1793
11
Jason Taft
[1.6.3.1.6.1.9.1.2.4.2]
b. 5 Jun 1796 d. 25 Oct 1861
10
Trial T Taft
[1.6.3.1.6.1.9.1.2.5]
b. 13 Apr 1777 d. 18 Aug 1815
9
Lois White
[1.6.3.1.6.1.9.1.3]
b. 25 Aug 1739 d. 7 Jan 1806
Edward Seagrave
b. Abt 1722 d. 20 May 1793
10
John Seagrave
[1.6.3.1.6.1.9.1.3.1]
b. 6 Nov 1757 d. 3 Feb 1842
10
Lois Seagrave
[1.6.3.1.6.1.9.1.3.2]
b. 5 Nov 1759 d. 8 Mar 1819
10
Sarah Sally Seagrave
[1.6.3.1.6.1.9.1.3.3]
b. 31 Dec 1760 d. 12 May 1851
10
Joseph Seagrave
[1.6.3.1.6.1.9.1.3.4]
b. 21 Dec 1761 d. 30 Aug 1830
10
Mary Seagrave
[1.6.3.1.6.1.9.1.3.5]
b. 1 Apr 1764 d. 1777
10
Bezaleel Seagrave
[1.6.3.1.6.1.9.1.3.6]
b. 14 Dec 1766 d. 1 Aug 1830
10
Caleb Seagrave
[1.6.3.1.6.1.9.1.3.7]
b. 14 Mar 1771 d. 22 Sep 1836
10
Josiah Seagrave
[1.6.3.1.6.1.9.1.3.8]
b. 14 Oct 1773 d. 20 Mar 1855
Lois Taft
b. 27 Aug 1780 d. 27 Apr 1854
11
Mary Ann Seagrave
[1.6.3.1.6.1.9.1.3.8.1]
b. 17 Nov 1799 d. 10 Feb 1825
11
Jacob Taft Seagraves
[1.6.3.1.6.1.9.1.3.8.2]
b. 8 Apr 1802 d. 24 Sep 1870
11
Henrietta Frost Seagrave
[1.6.3.1.6.1.9.1.3.8.3]
b. 1 Dec 1803 d. 1 Jun 1823
11
Waity Grant Seagrave
[1.6.3.1.6.1.9.1.3.8.4]
b. 23 Sep 1805 d. 27 Jan 1859
11
Edward Seagrave
[1.6.3.1.6.1.9.1.3.8.5]
b. 3 Sep 1807 d. 15 Feb 1873
11
Lois Taft Seagrave
[1.6.3.1.6.1.9.1.3.8.6]
b. 13 Apr 1809 d. 19 Mar 1853
11
Josiah Seagrave, Jr
[1.6.3.1.6.1.9.1.3.8.7]
b. 24 May 1811 d. 21 Jul 1861
11
Malvina Seagrave
[1.6.3.1.6.1.9.1.3.8.8]
b. 2 Apr 1813 d. 16 Dec 1823
11
Caleb Seagrave
[1.6.3.1.6.1.9.1.3.8.9]
b. 8 Feb 1815 d. 14 Nov 1823
11
Son Seagrave
[1.6.3.1.6.1.9.1.3.8.10]
b. 3 May 1817 d. 3 May 1817
11
Daughter Seagrave
[1.6.3.1.6.1.9.1.3.8.11]
b. 3 May 1817 d. 3 May 1817
11
Esborn Seagrave
[1.6.3.1.6.1.9.1.3.8.12]
b. 28 Dec 1818 d. 27 Oct 1856
11
George Augustus Seagrave
[1.6.3.1.6.1.9.1.3.8.13]
b. 6 Jan 1823 d. 15 Nov 1884
10
Edward Seagrave
[1.6.3.1.6.1.9.1.3.9]
b. 14 Oct 1773 d. 31 Jul 1797
10
Olive Seagrave
[1.6.3.1.6.1.9.1.3.10]
b. 17 Apr 1779 d. 1868
10
Samuel Seagraves
[1.6.3.1.6.1.9.1.3.11]
b. 3 Feb 1782 d. 4 Feb 1855
9
Joseph White
[1.6.3.1.6.1.9.1.4]
b. 1744 d. 1747
9
Judith White
[1.6.3.1.6.1.9.1.5]
b. 1746 d. 1747
9
Amos White
[1.6.3.1.6.1.9.1.6]
b. 1748 d. 1782
9
Joel White
[1.6.3.1.6.1.9.1.7]
b. 1751 d. 1835
9
Jesse White
[1.6.3.1.6.1.9.1.8]
b. 1754 d. 1830
9
Edward White
[1.6.3.1.6.1.9.1.9]
b. 1756 d. 1756
9
Abner White
[1.6.3.1.6.1.9.1.10]
b. 1758 d. 1758
9
Moses White
[1.6.3.1.6.1.9.1.11]
b. 1759 d. 1759
9
Eunice White
[1.6.3.1.6.1.9.1.12]
b. 1 Nov 1741 d. 3 Apr 1825
8
Peter White
[1.6.3.1.6.1.9.2]
b. 6 Dec 1714 d. 8 May 1782
Jemima Taft
b. 1 Apr 1713 d. 14 Oct 1787
9
Joseph White
[1.6.3.1.6.1.9.2.1]
b. 25 Jun 1738 d. 1805
9
Bethaih White
[1.6.3.1.6.1.9.2.2]
b. 1 Mar 1740 d. 1809
9
Elisabeth White
[1.6.3.1.6.1.9.2.3]
b. 13 Dec 1743
9
Peter White
[1.6.3.1.6.1.9.2.4]
b. 1746 d. 2 Dec 1821
9
Jemima White
[1.6.3.1.6.1.9.2.5]
b. Abt 1754 d. Abt 1782
9
Nathan White
[1.6.3.1.6.1.9.2.6]
b. 10 Jan 1755 d. 21 Jan 1828
8
Aaron White
[1.6.3.1.6.1.9.3]
b. 22 May 1717 d. Abt 1760
+
Susanah Benson
b. 2 Aug 1721 d. Aft 1750
8
Moses White
[1.6.3.1.6.1.9.4]
b. 31 Aug 1721
Abigail Holbrook
b. Abt 1721 d. 1787
9
Stephen White
[1.6.3.1.6.1.9.4.1]
b. 22 Sep 1754
9
Moses White
[1.6.3.1.6.1.9.4.2]
b. 24 Jul 1751
9
Abner White
[1.6.3.1.6.1.9.4.3]
b. 27 May 1753
8
Abigail White
[1.6.3.1.6.1.9.5]
b. 27 Jan 1723 d. 4 May 1751
Benoni Benson
b. 18 Jul 1724 d. 10 Jan 1806
9
Stephen Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1]
b. 15 Jul 1742 d. 30 Jul 1823
Mary Holbrook
b. 15 Jul 1745 d. 1849
10
Ichabod Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.1]
b. 30 Dec 1764 d. Aug 1794
Polly Herrick
b. 16 Aug 1763 d. 4 Oct 1847
11
Alonzo Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.1.1]
b. 6 Jan 1794 d. 4 Jun 1881
Abigail Johnston
b. 30 Aug 1795 d. 29 Feb 1880
12
Eliza Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.1.1.1]
b. 10 Nov 1820 d. 11 Oct 1846 [
=>
]
12
Alma Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.1.1.2]
b. 10 Sep 1821 d. 22 Jun 1921 [
=>
]
12
Lyman Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.1.1.3]
b. 10 Dec 1822 d. 18 Feb 1917 [
=>
]
12
Ichabod Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.1.1.4]
b. 19 Dec 1823 d. 22 Sep 1901
12
Alonzo Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.1.1.5]
b. 2 May 1826 d. 16 Nov 1876
12
Son Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.1.1.6]
b. 14 Jun 1827 d. 28 Jul 1827
12
Harvey Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.1.1.7]
b. 14 Jul 1828 d. 3 Jun 1864
12
Gaylord S Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.1.1.8]
b. 28 Sep 1829 d. 18 Jul 1918
12
Abbie J Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.1.1.9]
b. 22 Jan 1831
12
Lavantia E Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.1.1.10]
b. 4 Oct 1832 [
=>
]
12
Orson Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.1.1.11]
b. 18 Mar 1835 d. 30 Nov 1859
12
Mary Louise Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.1.1.12]
b. 7 Sep 1837 d. 12 Aug 1870 [
=>
]
10
Elkanah Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2]
b. 21 Feb 1766 d. 8 Mar 1844
Deobrah Wheelock
b. 17 Dec 1765 d. 3 Aug 1846
11
Samuel Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.1]
b. 21 May 1791
Mary Van Liew
b. 8 Jul 1797 d. 22 Apr 1859
12
William Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.1.1]
b. 18 Dec 1817
12
Emily Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.1.2]
b. 18 Dec 1817
12
Alzina Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.1.3]
b. 8 Nov 1819 d. 29 Mar 1867
12
Augustus Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.1.4]
b. 10 Feb 1822
12
Phila Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.1.5]
b. 8 Mar 1824 [
=>
]
12
Nathan S Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.1.6]
b. 17 Sep 1826 d. 1869 [
=>
]
12
James Mapes Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.1.7]
b. 12 Jun 1828 d. 11 Oct 1907 [
=>
]
12
Montgomery Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.1.8]
b. Abt 1833
12
Mary Ellen Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.1.9]
b. Abt 1839
11
Chloe Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.2]
b. 6 Jan 1793 d. 1882
Lewis Smith
b. Abt 1790
12
Mary Smith
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.2.1]
b. Abt 1813 d. 1913
12
Sidney Smith
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.2.2]
b. 29 Jan 1815 d. 10 Sep 1900 [
=>
]
12
William Smith
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.2.3]
b. Abt 1817
12
Lewis Smith
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.2.4]
b. Abt 1820
12
Stephen Smith
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.2.5]
b. 19 Feb 1823 d. 26 Aug 1922 [
=>
]
12
Job Lewis Smith
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.2.6]
b. 15 Oct 1827 d. 9 Jun 1897
11
Adolphus Willard Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.3]
b. 17 Dec 1795 d. 18 May 1878
Hannah Vermilyea
b. 1796 d. 28 Jun 1886
12
Edward Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.3.1]
b. 1824
12
Bryon L Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.3.2]
b. 25 Dec 1825 d. 23 Oct 1912 [
=>
]
12
Lewis Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.3.3]
b. Abt 1827
12
Elizabeth Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.3.4]
b. Abt 1829
12
Ellen Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.3.5]
b. Abt 1831
12
John Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.3.6]
b. Abt 1833
12
Henry Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.3.7]
b. Abt 1835
12
Jane H Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.3.8]
b. Abt 1837
12
Frank Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.3.9]
b. Abt 1839
11
Eliza Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.4]
b. 9 Mar 1798 d. 13 Nov 1817
+
James Miller
b. Abt 1795
11
Leonard Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.5]
b. 7 Apr 1800 d. 7 Sep 1877
Ruth Ann Reynolds
b. 23 Jul 1805 d. 2 Feb 1853
12
Elisha Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.5.1]
b. 1829 [
=>
]
12
William R Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.5.2]
b. 1831 d. 26 Feb 1889 [
=>
]
12
John Thompson Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.5.3]
b. 25 May 1833 d. 2 Apr 1914 [
=>
]
12
Emory J Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.5.4]
b. Jul 1836 d. 8 Mar 1926 [
=>
]
12
Finley E Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.5.5]
b. Abt 1841 [
=>
]
Hannah Sherman
12
Mary Isabelle Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.5.6]
b. 7 Jun 1853 d. 9 Dec 1935 [
=>
]
11
Phila Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.6]
b. 27 Jul 1802
Charles Warner
b. Abt 1800
12
Susan Warner
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.6.1]
b. 1828
12
Mary Warner
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.6.2]
b. 1830
12
Harriet Warner
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.6.3]
b. 1832
11
Calista Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.7]
b. 2 Jun 1804 d. 15 Sep 1882
Jacob Conklin
b. 19 Sep 1798 d. 1 Nov 1884
12
Sarah Conklin
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.7.1]
b. 1828
12
Edward Conklin
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.7.2]
b. Abt 1828
12
Sory Ann Conklin
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.7.3]
b. 1831 d. 7 Feb 1832
12
Benson Conklin
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.7.4]
b. May 1833 [
=>
]
12
John Conklin
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.7.5]
b. 1835 d. 25 Oct 1835
12
Maria Conklin
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.7.6]
b. 1837 d. 1850
12
Daughter Conklin
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.7.7]
b. 1840 d. 1840
12
Eugene Conklin
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.7.8]
b. 1841 d. 14 Apr 1912 [
=>
]
12
Daughter Conklin
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.7.9]
b. 1843 d. 3 Mar 1843
12
Lewis Smith Conklin
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.7.10]
b. Nov 1845 d. 28 Feb 1905 [
=>
]
12
Annette Conklin
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.7.11]
b. 1848 d. 22 Jun 1848
11
Ruth Wheelock Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.8]
b. 21 Sep 1807
William J Vermilyea
b. 7 Jul 1803 d. 30 Jun 1879
12
Francis Arvilla Vermilyea
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.8.1]
b. 19 Apr 1830 d. 19 Nov 1915 [
=>
]
12
Emily Benson Vermilyea
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.8.2]
b. 6 Dec 1831 d. Jun 1902 [
=>
]
12
Sidney Smith Vermilyea
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.8.3]
b. 27 Oct 1835 d. 22 Dec 1929 [
=>
]
12
Elkanah Benson Vermilyea
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.8.4]
b. 9 Sep 1837 d. 31 May 1838
12
Chauncey Vermilyea
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.8.5]
b. 25 Mar 1839 d. 16 Jun 1863
12
Eliza Prudence Vermilyea
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.8.6]
b. 4 Apr 1842 d. 1923 [
=>
]
12
John Benson Vermilyea
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.8.7]
b. 26 May 1844
12
Albert Gallatin Vermilyea
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.8.8]
b. 15 Sep 1846 [
=>
]
11
Sarah Elizabeth Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.9]
b. 1 Jul 1809 d. 20 Jul 1888
Leicester Dodge
b. 28 Apr 1808 d. 5 Sep 1843
12
Ermina P Dodge
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.9.1]
b. 14 Feb 1831
12
Henry Benson Dodge
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.9.2]
b. 3 Oct 1832 d. 16 Feb 1914 [
=>
]
12
Flora Elizabeth Dodge
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.9.3]
b. 6 Nov 1834
12
Sarah Janette Dodge
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.9.4]
b. 20 Sep 1836
12
Calista Augusta Dodge
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.9.5]
b. 23 Nov 1838 d. 29 Aug 1884
12
Caroline Emelia Dodge
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.9.6]
b. 30 Aug 1841 d. 7 Dec 1913 [
=>
]
12
Lester Lewis Dodge
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.2.9.7]
b. 30 Oct 1843
10
Esther Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.3]
b. 8 Dec 1768 d. 31 Mar 1855
Isaac Staples
b. 9 Mar 1742 d. 29 May 1848
11
Esther Staples
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.3.1]
b. Abt 1790 d. 17 May 1878
11
Abraham Staples
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.3.2]
b. 12 Mar 1792 d. 5 Sep 1881
11
Scammel Staples
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.3.3]
b. 29 Dec 1798 d. 5 Apr 1883
11
Warren Staples
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.3.4]
b. 17 Jan 1802
11
Evaline Staples
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.3.5]
b. 11 Aug 1807 d. 2 Oct 1858
10
Ezekial Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.4]
b. 13 Mar 1770
10
Phila Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.5]
b. 23 Feb 1772
Phineas Tyler
b. 14 Feb 1765 d. 21 Jan 1847
11
Daniel Tyler
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.5.1]
b. 2 Aug 1791
11
Phila Tyler
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.5.2]
b. Abt 1793
11
Mary Tyler
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.5.3]
b. 30 Mar 1794 d. 5 Aug 1885
Captain Henry Austin
b. 30 Jan 1782 d. 23 Jan 1852
12
Mary Austin
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.5.3.1]
b. 2 Aug 1815 d. 1832
12
Emily Austin
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.5.3.2]
b. 11 Nov 1817 d. 28 Jan 1860
12
Harriet Austin
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.5.3.3]
b. 23 Nov 1819 d. 25 Feb 1858
12
Edward Taylor Austin
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.5.3.4]
b. 26 Jul 1822
12
John Thompson Austin
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.5.3.5]
b. 13 Jun 1824 d. 26 Dec 1842
10
Polly Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.6]
b. 7 Nov 1773
John Robinson
b. Abt 1769
11
Tryphenia Robinson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.6.1]
b. Abt 1795
11
Lydia Robinson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.6.2]
b. Abt 1797
11
Ezekial Robinson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.6.3]
b. Abt 1799
11
Hiram Robinson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.6.4]
b. Abt 1801
11
Andrew Robinson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.6.5]
b. Abt 1803
11
John Robinson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.6.6]
b. Abt 1805
11
Norman Robinson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.6.7]
b. Abt 1807
10
Sally Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.7]
b. 13 Feb 1776 d. 24 Nov 1837
Amos Boyden
b. 1766 d. 30 Apr 1836
11
Abigail Boyden
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.7.1]
b. 6 Aug 1791
Allen Richardson
12
Sally Ann Richardson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.7.1.1]
b. 14 Jan 1816
12
Nancy L Richardson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.7.1.2]
b. 13 Apr 1818 d. 10 Jun 1895 [
=>
]
12
Isaac A Richardson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.7.1.3]
b. 26 Nov 1820
12
Susan Amy Richardson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.7.1.4]
b. 21 Feb 1823
12
Asenath T Richardson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.7.1.5]
b. 5 May 1825
12
Fanny J Richardson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.7.1.6]
b. 29 Nov 1827
12
Albert S Richardson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.7.1.7]
b. 18 Feb 1832 d. 8 Aug 1832
12
Allen Richardson
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.7.1.8]
d. 29 Apr 1835
11
Aseneth Boyden
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.7.2]
b. 10 Sep 1794 d. Apr 1886
+
Ellis Taft
b. 23 May 1796 d. 27 Aug 1851
11
David Boyden
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.7.3]
b. 11 Mar 1797
11
Nancy Boyden
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.7.4]
b. 23 Mar 1799
+
Salem Town
b. 1802
11
Sally Boyden
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.7.5]
b. 3 Apr 1806 d. 13 Sep 1808
11
William Collins Boyden
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.7.6]
b. 14 May 1801 d. 30 Nov 1803
11
Joel Boyden
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.7.7]
b. 7 Jul 1803 d. 2 Aug 1835
Mary Andrews
b. 1808 d. 12 Mar 1829
12
Amos Boyden
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.7.7.1]
b. 4 Aug 1827 [
=>
]
+
Rebecca Stearns
b. 1797 d. Apr 1833
11
Amy Smith Boyden
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.7.8]
b. 10 Jul 1808 d. 31 Jul 1838
11
William Collins Boyden
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.7.9]
b. 8 May 1811
Emily M Mowry
b. 13 Oct 1814 d. 25 May 1880
12
Mary Amanda Boyden
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.7.9.1]
b. 16 Aug 1834 [
=>
]
12
William Collins Boyden
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.7.9.2]
b. 3 Apr 1836 d. 20 Mar 1882
12
Sanford H Boyden
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.7.9.3]
b. 20 Dec 1838 d. 18 Sep 1869
12
Decatur M Boyden
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.7.9.4]
b. 21 Aug 1840 d. Abt 1951 [
=>
]
12
Emily Frances Boyden
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.7.9.5]
b. 19 Jan 1845 d. 17 Sep 1846
12
Emily Ann Boyden
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.7.9.6]
b. 10 Jan 1848 d. Abt 1958
12
Reuben M Boyden
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.7.9.7]
b. 19 Dec 1853 d. 5 Sep 1887
12
Amey Boyden
[1.6.3.1.6.1.9.5.1.7.9.8]
b. 23 May 1856 d. 30 Sep 1915
9
Henry Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.2]
b. 5 Dec 1743 d. 7 Dec 1777
Susanna Thayer
b. 23 Apr 1746 d. 4 Jan 1808
10
Hannah Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.2.1]
b. 7 May 1764
+
Aaron Legg
10
Joanna Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.2.2]
b. 6 Jul 1766 d. 29 Dec 1820
Daniel Holbrook
b. 7 Feb 1765 d. 10 Jun 1831
11
Henry Benson Holbrook
[1.6.3.1.6.1.9.5.2.2.1]
b. 21 Aug 1788 d. 1870
Rebecca Austin
b. 27 Oct 1796
12
Isaac Holbrook
[1.6.3.1.6.1.9.5.2.2.1.1]
b. 7 Nov 1816 d. 19 Apr 1875
12
Betsy Holbrook
[1.6.3.1.6.1.9.5.2.2.1.2]
b. 1821 d. 6 Dec 1897
12
Francis M Holbrook
[1.6.3.1.6.1.9.5.2.2.1.3]
b. 20 Jul 1823 d. 7 May 1906 [
=>
]
12
Charles Holbrook
[1.6.3.1.6.1.9.5.2.2.1.4]
b. 1834
11
Marcus Holbrook
[1.6.3.1.6.1.9.5.2.2.2]
b. Abt 1791 d. Aft 1840
+
Abigail Wild
11
Lydia Holbrook
[1.6.3.1.6.1.9.5.2.2.3]
b. Abt 1793 d. 19 Feb 1820
11
Daniel Holbrook
[1.6.3.1.6.1.9.5.2.2.4]
b. 28 Feb 1796 d. 18 Oct 1864
11
Rufus Holbrook
[1.6.3.1.6.1.9.5.2.2.5]
b. Abt 1801
Mary Wyman
b. 1801
12
Atward D Holbrook
[1.6.3.1.6.1.9.5.2.2.5.1]
b. 1831 d. 1900 [
=>
]
11
Abraham Staples Holbrook
[1.6.3.1.6.1.9.5.2.2.6]
b. Abt 1806 d. 1 May 1862
+
Sally Dearborn
b. 22 Jun 1807 d. 20 Mar 1863
11
Millins Holbrook
[1.6.3.1.6.1.9.5.2.2.7]
b. Abt 1808
Laura Temple
b. 5 May 1808 d. 12 Sep 1864
12
Harriet Elizabeth Holbrook
[1.6.3.1.6.1.9.5.2.2.7.1]
b. 14 Jan 1835 [
=>
]
12
Daniel Henry Holbrook
[1.6.3.1.6.1.9.5.2.2.7.2]
b. 9 Feb 1841
12
Fanny Maria Holbrook
[1.6.3.1.6.1.9.5.2.2.7.3]
b. 24 Dec 1841
12
George Benson Holbrook
[1.6.3.1.6.1.9.5.2.2.7.4]
b. Sep 1846 d. 4 Jul 1922 [
=>
]
10
Abigail Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.2.3]
b. 2 Jul 1768
+
Henry Staples
10
Henry Staples Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.2.4]
b. 8 Aug 1770 d. 29 Jul 1821
Lydia Sibley
b. 2 Apr 1769 d. 27 Nov 1822
11
Abigail Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.2.4.1]
b. 31 Mar 1795 d. 10 Nov 1821
Asa Legg
b. 7 May 1792 d. 15 Nov 1836
12
Charlotte Legg
[1.6.3.1.6.1.9.5.2.4.1.1]
b. 2 May 1818 d. 30 Oct 1900 [
=>
]
12
Lyman Legg
[1.6.3.1.6.1.9.5.2.4.1.2]
b. 3 Sep 1822 d. 1 Sep 1904 [
=>
]
11
Harriet Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.2.4.2]
b. 14 Sep 1796 d. 22 Aug 1852
11
Mellen Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.2.4.3]
b. 14 Jan 1798
Eliza W Farnum
b. 25 Sep 1802 d. 14 Sep 1839
12
Henry Staples Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.2.4.3.1]
b. 17 May 1829
12
Almira Farnum Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.2.4.3.2]
b. 6 Aug 1830 d. 25 Dec 1835
12
James Haskins Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.2.4.3.3]
b. 16 Oct 1833
12
George Everett Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.2.4.3.4]
b. 14 Aug 1837
+
Mary Windsor Peck
b. 21 May 1798
11
Hannah Adaline Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.2.4.4]
b. 12 Aug 1802 d. 19 Jun 1822
11
Rufus Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.2.4.5]
b. 24 Jan 1804 d. 23 Aug 1805
11
Chloe Ann Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.2.4.6]
b. 23 Aug 1806
+
Dan Hill
b. 29 Nov 1796
11
Susan Augusta Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.2.4.7]
b. 9 Oct 1809 d. 25 Jul 1831
Preserved Smith Thayer
b. 9 May 1808
12
Susan Benson Thayer
[1.6.3.1.6.1.9.5.2.4.7.1]
b. 28 Jun 1831 d. 14 Aug 1909
11
Rufus Aldrich Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.2.4.8]
b. 9 Oct 1809
+
Sarah E Buell
11
Stephen Sibley Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.2.4.9]
b. 9 Jan 1810 d. 20 Nov 1869
Elizabeth Richardson Scott
b. 8 Jan 1835 d. 20 Feb 1911
12
Jessie Harriet Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.2.4.9.1]
b. 7 Jun 1860
12
Fred Mellen Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.2.4.9.2]
b. 10 Nov 1862 d. 9 May 1864
12
Susie Adeline Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.2.4.9.3]
b. 6 Aug 1865
10
Tirza Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.2.5]
b. 29 Apr 1772
Wilder Johnson
b. 1768
11
Elmira Johnson
[1.6.3.1.6.1.9.5.2.5.1]
b. 1810 d. 27 May 1816
10
Susanna Thayer Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.2.6]
b. 19 Feb 1775
+
Gideon Angel
b. Abt 1770
10
Rachel Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.2.7]
b. 5 May 1777 d. 21 Nov 1842
General Charles Jenckes
b. 7 Aug 1767 d. 4 Jul 1838
11
Charles Benson Jenckes
[1.6.3.1.6.1.9.5.2.7.1]
b. 10 Apr 1796 d. Aft 1831
Hannah Ellis Thayer
b. 19 Mar 1800 d. 26 Feb 1818
12
Charles T Jenckes
[1.6.3.1.6.1.9.5.2.7.1.1]
b. 20 Feb 1818 d. 28 Feb 1818
Urana Thayer
b. 26 Dec 1801 d. 15 Nov 1822
12
Rufus A Jenckes
[1.6.3.1.6.1.9.5.2.7.1.2]
b. 22 Sep 1822 d. 11 Oct 1822
+
Alice T Thayer
b. Abt 1802 d. 28 Mar 1826
Ann Eliza Smith
b. 31 Dec 1805 d. 2 Apr 1865
12
Hannah Eliza Jenckes
[1.6.3.1.6.1.9.5.2.7.1.3]
b. 25 Nov 1827 d. 22 Oct 1890
12
Charles Henry Jenckes
[1.6.3.1.6.1.9.5.2.7.1.4]
b. 17 Nov 1829 d. 1862 [
=>
]
12
Ann Mariah Jenckes
[1.6.3.1.6.1.9.5.2.7.1.5]
b. 31 Dec 1831 d. 31 Jul 1910 [
=>
]
9
Joanna Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.3]
b. 14 Nov 1745 d. Bef 1806
9
Benoni Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.4]
b. 11 Jul 1747 d. 1803
Ruth Holbrook
b. 10 Aug 1751 d. 16 May 1781
10
Amasa Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.4.1]
b. 25 Jan 1771 d. 7 Mar 1837
Levina Turtilot
b. 20 Feb 1777 d. 1 May 1865
11
Henry Holbrook Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.4.1.1]
b. 22 Mar 1801
Almira A
b. 26 Aug 1817
12
Leander A Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.4.1.1.1]
b. 1838 d. 10 Aug 1839
12
Henry A Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.4.1.1.2]
b. 23 Feb 1843 d. 19 Aug 1844
12
Seth Hall Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.4.1.1.3]
b. 6 Jul 1847 d. 1915
12
Edwin Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.4.1.1.4]
b. Abt 1851
11
James Davis Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.4.1.2]
b. 15 Nov 1802 d. 5 Sep 1805
11
Chloe Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.4.1.3]
b. 2 Oct 1804 d. 28 Mar 1844
Horace B Robbins
b. 28 Mar 1797 d. 24 Feb 1879
12
Alvin Cook Robbins
[1.6.3.1.6.1.9.5.4.1.3.1]
b. 12 May 1828 [
=>
]
12
Ann Mariah Robbins
[1.6.3.1.6.1.9.5.4.1.3.2]
b. 6 Jul 1830
12
Henry Davis Robbins
[1.6.3.1.6.1.9.5.4.1.3.3]
b. 22 Sep 1834
12
Charles W Robbins
[1.6.3.1.6.1.9.5.4.1.3.4]
b. Abt 1837
12
Sanford Augustus Robbins
[1.6.3.1.6.1.9.5.4.1.3.5]
b. 9 May 1840
11
Maria R Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.4.1.4]
b. 17 Dec 1806
Alvin Cook
b. 1805 d. 9 Jun 1872
12
Ellen L Cook
[1.6.3.1.6.1.9.5.4.1.4.1]
b. 1830
12
Miriam A Cook
[1.6.3.1.6.1.9.5.4.1.4.2]
b. Oct 1834 d. 24 Mar 1835
12
Aaron Cook
[1.6.3.1.6.1.9.5.4.1.4.3]
b. 26 Jun 1837
12
Samantha Maria Cook
[1.6.3.1.6.1.9.5.4.1.4.4]
b. Abt 1841 [
=>
]
12
Alice Salina Cook
[1.6.3.1.6.1.9.5.4.1.4.5]
b. 26 Feb 1844
12
Winfield E Cook
[1.6.3.1.6.1.9.5.4.1.4.6]
b. 21 Jun 1847
12
Ellen Louisa Cooke
[1.6.3.1.6.1.9.5.4.1.4.7]
c. 3 Sep 1843
11
Charles Holbrook Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.4.1.5]
b. 14 Sep 1809
+
Adaline M Hayward
b. 22 Feb 1823
11
Angeline Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.4.1.6]
b. 20 Jul 1811
11
Ann Eliza Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.4.1.7]
b. 20 Feb 1813
11
Elsa T Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.4.1.8]
b. 17 Jul 1815
11
Nathan Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.4.1.9]
b. 30 Nov 1817
11
William Hall Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.4.1.10]
b. 24 Oct 1819
10
Chloe Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.4.2]
b. 28 Jan 1774
10
Benoni Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.4.3]
b. 1780 d. 1819
Ruth Sibley
b. 9 Apr 1745 d. 30 Nov 1814
10
John Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.4.4]
b. 1789
9
John Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5]
b. 1 Aug 1749 d. 18 May 1818
Mary Holbrook
b. 1 Feb 1762 d. 27 Dec 1814
10
John Perry Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.1]
b. 22 Jul 1781 d. 21 Jan 1842
Chloe Taft
b. 7 Jul 1785 d. 25 Apr 1826
11
Charlotte Taft Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.1.1]
b. 30 Sep 1807 d. 16 Jul 1878
Moses Dyer
b. 1803 d. Aft 1841
12
Merril B Dyer
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.1.1.1]
b. 2 Apr 1844 d. 2 Apr 1859
12
George Franklin Dyer
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.1.1.2]
b. 22 Jan 1846 d. 27 Feb 1917 [
=>
]
12
Chloe Allice Dyer
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.1.1.3]
b. 5 May 1848 d. 1932 [
=>
]
12
Angelne A Dyer
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.1.1.4]
b. 6 Sep 1852 [
=>
]
11
Ezra Taft Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.1.2]
b. 22 Feb 1811 d. 3 Sep 1869
Pamelia Andrus
b. 21 Oct 1809 d. 14 Sep 1877
12
Charles Agustus Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.1.2.1]
b. 26 Sep 1832 d. 14 Oct 1833
12
Chloe Jane Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.1.2.2]
b. 1835 d. 1835
12
Charles Augustus Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.1.2.3]
b. 9 Jul 1837 d. 18 Feb 1873
12
Jonathan Parsons Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.1.2.4]
b. Mar 1841 d. Mar 1841
12
Adin Parsons Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.1.2.5]
b. Mar 1841 d. Mar 1841
12
Pamelia Emma Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.1.2.6]
b. 28 Feb 1842 d. 10 Feb 1892
12
Harvey Andrus Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.1.2.7]
b. 26 Sep 1844 d. 26 Sep 1844
12
Isabella Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.1.2.8]
b. 9 Mar 1846 d. 10 Feb 1922
12
Charlotte Taft Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.1.2.9]
b. 4 Jul 1850 d. 30 Nov 1918 [
=>
]
Adeline Brooks Andrus
b. 18 Mar 1813 d. 20 Apr 1898
12
George Taft Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.1.2.10]
b. 1 May 1846 d. 16 May 1919 [
=>
]
12
Florence Adeline Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.1.2.11]
b. 17 Sep 1851 d. 25 Dec 1852
12
Nellie Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.1.2.12]
b. 30 Nov 1851 d. 24 Jan 1885
12
Frank Andrus Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.1.2.13]
b. 16 Oct 1853 d. 5 May 1937 [
=>
]
12
Samuel Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.1.2.14]
b. 1853
Eliza Ann Perry
b. 30 Mar 1828 d. 30 Apr 1913
12
Alice Eliza Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.1.2.15]
b. 11 Aug 1848 d. 3 Jun 1923
12
John Perry Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.1.2.16]
b. 24 Sep 1849 d. 4 Jan 1921
12
Malina Adelaide Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.1.2.17]
b. 21 Sep 1851 d. 31 Jul 1918
12
Orrin William Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.1.2.18]
b. 4 Oct 1853 d. 17 May 1917
12
Carrie Stella Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.1.2.19]
b. 22 May 1860 d. 15 Mar 1928
12
Abbie Della Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.1.2.20]
b. 16 Oct 1862 d. 22 Oct 1925
12
Grace Ann Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.1.2.21]
b. 31 Jan 1867 d. 15 Dec 1924
Elizabeth Gollaher
b. 30 Dec 1831 d. 4 May 1904
12
Fredrick Gollaher Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.1.2.22]
b. 17 Jan 1855 d. 6 Jan 1915
12
Brigham Young Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.1.2.23]
b. 17 Dec 1858 d. 11 Jul 1938
12
Luella Gollaher Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.1.2.24]
b. 12 Nov 1860 d. 22 Jul 1881
12
William C Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.1.2.25]
b. 11 Nov 1862 d. Sep 1937
12
Hyrum Smith Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.1.2.26]
b. 3 May 1864 d. 4 May 1935
12
Edith Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.1.2.27]
b. 22 Apr 1867 d. 11 Feb 1925
12
Lizzie Gollaher Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.1.2.28]
b. 9 Jul 1869 d. 30 Jul 1946
Olive Mary Knight
b. 24 Jan 1830 d. 27 Mar 1905
12
Louisa Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.1.2.29]
b. 29 Jun 1852 d. 29 Nov 1878
12
Heber Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.1.2.30]
b. Abt 1860 d. Bef 1868
12
Moroni Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.1.2.31]
b. 5 Nov 1861 d. 8 Jan 1934
12
Lorenzo Taft Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.1.2.32]
b. 3 Aug 1863 d. 6 Nov 1950
12
Joseph Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.1.2.33]
b. 13 Jul 1865 d. 5 Jun 1941
12
Ida May Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.1.2.34]
b. 16 Apr 1867 d. 30 Jun 1929
12
Don Carlos Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.1.2.35]
b. 29 Sep 1869 d. 19 Jan 1935
Mary Marie Larsen
b. 19 Dec 1843 d. 21 Feb 1926
12
Walter Taft Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.1.2.36]
b. 17 Jun 1867 d. 6 Jun 1957
12
Henry Taft Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.1.2.37]
b. 19 Mar 1869 d. 24 Feb 1947
+
Desdemona Wadsworth Fullmer
b. 6 Oct 1809 d. 9 Feb 1886
+
Lucinda Burton
b. 22 Oct 1825 d. 1 Oct 1863
11
George Taft Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.1.3]
b. Abt 1813
Prudence Maria Gifford
b. Abt 1815
12
Walter Everet Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.1.3.1]
b. 13 Sep 1857 d. 29 Apr 1907 [
=>
]
11
Hannah Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.1.4]
b. 18 Sep 1816
Henry Dodge
b. 15 Dec 1812 d. 22 Jun 1883
12
John M Dodge
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.1.4.1]
b. 1838 d. 14 Feb 1898
12
Abbie R Dodge
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.1.4.2]
b. 1850 d. 27 Sep 1916 [
=>
]
11
Abbie Ann Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.1.5]
b. Abt 1809 d. 21 Sep 1883
Calvin Rawson
b. 13 May 1797 d. 21 Jan 1868
12
Son Rawson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.1.5.1]
b. Abt 1828 d. Abt 1838
11
John M Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.1.6]
b. 1819 d. 12 Aug 1829
10
George Washington Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.2]
b. 25 May 1783 d. 10 Nov 1855
Alinda Warfield
b. 24 Aug 1785 d. 25 Apr 1841
11
Otis Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.2.1]
b. 28 Feb 1806 d. 16 Feb 1811
11
Harrison Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.2.2]
b. 10 Oct 1820 d. 25 Oct 1859
Marilla Adams
b. 12 Apr 1818 d. 16 Oct 1876
12
George Otis Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.2.2.1]
b. 24 Aug 1846 d. 2 May 1897
12
Reuben Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.2.2.2]
b. 1 Jan 1856 d. 25 Jul 1922
10
Jared Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.3]
b. 3 Feb 1785 d. 31 Jul 1854
Salley Taft
b. 21 Oct 1787 d. 7 Aug 1855
11
James Sulliven Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.3.1]
b. 19 Sep 1808 d. 3 Jan 1833
11
Putman Taft Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.3.2]
b. 28 Oct 1814 d. 24 Apr 1834
11
Jared Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.3.3]
b. 8 Nov 1821 d. 18 May 1894
Martha Taft
b. 23 Feb 1826 d. 19 Feb 1903
12
Sullivan Theodore Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.3.3.1]
b. 20 Apr 1844 d. 21 Sep 1911
12
Jared Irving Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.3.3.2]
b. 6 Oct 1846 d. 1919 [
=>
]
12
Walter Bryant Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.3.3.3]
b. 16 Jan 1850 d. 10 Feb 1860
12
Grace Sally Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.3.3.4]
b. 2 Sep 1852 d. 25 Feb 1863
11
Sylvanus Holbrook Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.3.4]
b. 23 Jun 1828 d. 1878
Laurett V Howard
b. 1830 d. 1860
12
Ellen Laura Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.3.4.1]
b. 18 Aug 1851 [
=>
]
12
Ernest S Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.3.4.2]
b. 25 May 1855
12
Laurett Victoria Howard Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.3.4.3]
b. 1859 d. 3 Jul 1883 [
=>
]
Lottie E. Kelly
12
Lottie E. Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.3.4.4]
b. 20 Sep 1866
10
Abigail Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.4]
b. 13 Feb 1787
Putman Taft
b. 5 Aug 1783 d. 20 Feb 1810
11
Mary Ann Taft
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.4.1]
b. 23 Oct 1807
+
Samuel T Holroyd
b. 1791 d. 4 Nov 1817
+
Angel Sweet
b. 7 Apr 1790 d. 28 Apr 1825
+
Edward Ide Bower
+
Joseph McDermott
10
Mary "Polly" Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.5]
b. 9 Jun 1788 d. 12 Jan 1864
Bailey Legg
b. 9 May 1783 d. 11 Oct 1862
11
Sylvanus B Legg
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.5.1]
b. 20 Jun 1813 d. Bef 8 Jun 1885
11
Mary H Legg
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.5.2]
b. 7 Jul 1815
11
Harriet H Legg
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.5.3]
b. 14 Jun 1817
10
Phyba Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.6]
b. Abt 1790
10
Prudence Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.7]
b. 7 Jul 1795
10
Thankful Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.8]
b. 26 Nov 1799 d. 1 May 1852
Joseph Bartlett Cook
b. 3 Dec 1796 d. 6 Oct 1856
11
William Walker Cook
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.8.1]
b. 21 Mar 1820
Nancy Marion Draper
b. 17 Mar 1823
12
Edwin L Cook
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.8.1.1]
b. 29 Mar 1857
11
Amanda Melvina Cook
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.8.2]
b. 12 Oct 1821
11
Mary Adeliza Cook
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.8.3]
b. 18 Apr 1824
11
Emily Caroline Cook
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.8.4]
b. 8 Feb 1826 d. 7 Mar 1826
11
Elma Ann Cook
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.8.5]
b. 29 Jan 1827 d. 13 Jan 1870
William Gibbs Comstock
b. 3 Feb 1827 d. 29 Apr 1914
12
Alice Ardella Comstock
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.8.5.1]
b. 10 Dec 1850 d. 20 Sep 1914 [
=>
]
12
Fanny Amanda Comstock
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.8.5.2]
b. 4 Jul 1854 d. 2 Sep 1934
10
Sulvanus Holbrook Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.9]
b. 12 Jan 1797 d. 24 Aug 1812
10
Judson Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.10]
b. Abt 1801 d. 15 Oct 1813
Joanna Taft
b. 14 Nov 1751 d. 3 Oct 1777
10
Lovett Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.11]
b. 6 Oct 1772 d. 4 Mar 1773
10
Lois Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.12]
b. 17 Jul 1774 d. 10 Jul 1840
Manassah Baker
b. 4 Oct 1765 d. 30 Jun 1831
11
Sarah Williams Baker
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.12.1]
b. 8 Feb 1796
Andre Taft
b. 25 Jun 1792 d. 26 Jun 1850
12
Margary Ann Taft
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.12.1.1]
b. 4 May 1818 d. 4 Nov 1904 [
=>
]
12
Caroline Taft
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.12.1.2]
b. 21 Aug 1821 d. 7 Nov 1907 [
=>
]
11
Sawyer Baker
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.12.2]
b. 5 Nov 1797 d. 14 Oct 1802
11
Mary Sawyer Baker
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.12.3]
b. 1 Apr 1800
11
Bezaleel Sawyer Baker
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.12.4]
b. 13 Sep 1802
11
William Henry Baker
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.12.5]
b. 8 Jun 1805
11
Chloe Taft Baker
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.12.6]
b. 17 Dec 1807
Faton Walker
12
Henry E Walker
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.12.6.1]
b. 15 Mar 1836
12
Harriet E Walker
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.12.6.2]
b. 15 Mar 1836 d. 30 Nov 1837
12
Edmund Walker
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.12.6.3]
b. 18 Dec 1837 d. 10 May 1844
12
Edgar Walker
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.12.6.4]
b. 18 Dec 1837 d. 24 Jan 1844
12
Adeline N Walker
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.12.6.5]
b. 7 Feb 1845 d. 1848
11
John William Baker
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.12.7]
b. 29 Sep 1810
11
Hannah Dike Baker
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.12.8]
b. 8 Nov 1813 d. 3 Jul 1836
11
John Brooks Baker
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.12.9]
b. 30 Jul 1816
11
Caleb Strong Baker
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.12.10]
b. 30 Jul 1816 d. 29 Dec 1834
10
Prudence Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.5.13]
b. 4 May 1776 d. 16 May 1789
9
Ichabod Benson
[1.6.3.1.6.1.9.5.6]
b. 4 May 1751 d. Bef 1806
8
Sarah White
[1.6.3.1.6.1.9.6]
b. 8 Nov 1724
8
Ebenezer White
[1.6.3.1.6.1.9.7]
b. 20 Nov 1726 d. 10 May 1812
Elizabeth Ellis
b. 10 Dec 1729
9
Ellis White
[1.6.3.1.6.1.9.7.1]
b. 13 Oct 1748
9
Turner White
[1.6.3.1.6.1.9.7.2]
b. Abt 1750 d. 6 Aug 1836
9
Abigail White
[1.6.3.1.6.1.9.7.3]
b. 9 Sep 1752
9
Smith White
[1.6.3.1.6.1.9.7.4]
b. 9 Oct 1755 d. 18 Apr 1823
9
Philadelphia White
[1.6.3.1.6.1.9.7.5]
b. 6 Oct 1760
9
Melatiah White
[1.6.3.1.6.1.9.7.6]
b. Abt 18 May 1766
9
Stephen White
[1.6.3.1.6.1.9.7.7]
b. 11 May 1761 d. 20 Oct 1860
8
Prudence White
[1.6.3.1.6.1.9.8]
b. 24 Sep 1729 d. Feb 1787
James Albee
b. 12 Mar 1721 d. 24 Nov 1795
9
Hope Albee
[1.6.3.1.6.1.9.8.1]
b. Abt 1765 d. 18 Jan 1840
Stephen Holbrook
b. 19 Jun 1764 d. 16 Aug 1830
10
Rachel Holbrook
[1.6.3.1.6.1.9.8.1.1]
b. 22 Apr 1789
10
Sylvanus Holbrook
[1.6.3.1.6.1.9.8.1.2]
b. 28 Jul 1792 d. 9 Dec 1855
10
Willard Holbrook
[1.6.3.1.6.1.9.8.1.3]
b. 7 Apr 1795 d. 4 Mar 1862
10
Wilder Holbrook
[1.6.3.1.6.1.9.8.1.4]
b. 7 Apr 1795 d. 2 Jan 1855
10
Chloe Holbrook
[1.6.3.1.6.1.9.8.1.5]
b. 13 Aug 1801 d. 11 Aug 1855
10
Henry Holbrook
[1.6.3.1.6.1.9.8.1.6]
b. 19 Apr 1804 d. 10 Jul 1874
10
Ellery Holbrook
[1.6.3.1.6.1.9.8.1.7]
b. 26 Jun 1810 d. 10 Jul 1847
9
Rachael Albee
[1.6.3.1.6.1.9.8.2]
b. Abt 1748 d. 1832
9
Lois Albee
[1.6.3.1.6.1.9.8.3]
b. 15 Feb 1759 d. 1841
9
Eunice Albee
[1.6.3.1.6.1.9.8.4]
b. 20 Apr 1763 d. 1845
9
James Albee
[1.6.3.1.6.1.9.8.5]
b. 11 Mar 1753 d. 18 Aug 1814
9
Abigail Albee
[1.6.3.1.6.1.9.8.6]
b. 1747 d. 1844
9
Alpheus Albee
[1.6.3.1.6.1.9.8.7]
b. 15 Feb 1761 d. 1847
9
Prudance Albe
[1.6.3.1.6.1.9.8.8]
b. 18 Jan 1770 d. 1795
9
Abiel Albee
[1.6.3.1.6.1.9.8.9]
b. 1756 d. 1827
8
Rachael White
[1.6.3.1.6.1.9.9]
b. 14 Nov 1732 d. 19 Mar 1808
Thomas Darling
b. 7 May 1730 d. 22 Oct 1776
9
Seth Darling
[1.6.3.1.6.1.9.9.1]
b. 21 Mar 1764 d. 27 Mar 1825
9
Nathan Darling
[1.6.3.1.6.1.9.9.2]
b. 17 Dec 1770 d. 7 Sep 1855
9
Simeon Darling
[1.6.3.1.6.1.9.9.3]
b. 21 Mar 1760 d. 4 Jun 1812
9
John Darling
[1.6.3.1.6.1.9.9.4]
b. 9 Jun 1768
9
Alpheus Darling
[1.6.3.1.6.1.9.9.5]
b. Abt 1770
9
Rhoda Darling
[1.6.3.1.6.1.9.9.6]
b. 8 May 1750 d. 25 Jan 1842
9
Joanna Darling
[1.6.3.1.6.1.9.9.7]
b. 1 Feb 1752
9
Rachel Darling
[1.6.3.1.6.1.9.9.8]
b. 1 May 1755 d. Bef 1818
Reuben Holbrook
b. 18 Jul 1754 d. 1835
10
Abigail Holbrook
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.1]
b. 8 Jan 1778
10
Rachael Holbrook
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.2]
b. 8 Jan 1780
Foster Verry
b. 7 Oct 1789 d. 1860
11
Albert Verry
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.2.1]
b. 15 Jul 1812
11
James Verry
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.2.2]
b. 27 Feb 1814
Nancy Nolen
12
Ester Jane Verry
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.2.2.1]
b. 19 Aug 1836 d. 10 Aug 1847
12
Isadore Verry
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.2.2.2]
b. 10 Jul 1839 [
=>
]
11
Chloe Holbrook Verry
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.2.3]
b. 20 Mar 1816
David Smith Wilder
b. 20 Aug 1813 d. 13 Nov 1898
12
Albert Verry Wilder
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.2.3.1]
b. 6 Feb 1838 d. Bef 1948
12
Foster Verry Wilder
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.2.3.2]
b. 16 Apr 1839 d. Bef 1949
12
Abel Wilder
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.2.3.3]
b. Abt 1840 d. Bef 1845
12
Chloeanna Wilder
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.2.3.4]
b. Abt 1842 d. Bef 1846
12
Clara Deetta Wilder
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.2.3.5]
b. Abt 1844 d. Bef 1850
12
Deetta Wilder
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.2.3.6]
b. Abt 1845 d. Bef 1851
11
Sally Verry
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.2.4]
b. 30 Apr 1818
11
Foster Verry
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.2.5]
b. 3 Oct 1821 d. 29 Jun 1837
10
Prudence Holbrook
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.3]
b. 25 Feb 1782
10
Anna Holbrook
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.4]
b. 30 Mar 1784 d. 16 Mar 1851
Samuel Fairbanks
b. 8 Apr 1784 d. 22 Jul 1845
11
Samuel Fairbanks
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.4.1]
b. Feb 1803 d. Aft 1852
11
Hester Fairbanks
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.4.2]
b. 11 Apr 1804 d. Bef 1825
11
Mary Ann Fairbanks
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.4.3]
b. 27 Apr 1806 d. 1858
Elhanim Hartwell
b. 1819
12
Eunice Elsie Hartwell
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.4.3.1]
b. 7 May 1849 [
=>
]
11
Elizabeth Fairbanks
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.4.4]
b. 14 Nov 1814 d. 12 Oct 1872
Stewart Smiley
b. Abt 1808 d. 1892
12
William G Smiley
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.4.4.1]
12
Thomas J Smiley
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.4.4.2]
12
Charels E Smiley
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.4.4.3]
12
Stuart Smiley
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.4.4.4]
12
Adelbert Smiley
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.4.4.5]
12
Frank B Smiley
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.4.4.6]
12
Abbie Smiley
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.4.4.7]
12
George Smiley
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.4.4.8]
12
Adelia Smiley
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.4.4.9]
12
Melvina Smiley
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.4.4.10]
12
Susan Smiley
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.4.4.11]
12
Mary Ann Smiley
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.4.4.12]
12
Fredrick Lee Smiley
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.4.4.13]
b. 23 Oct 1853 d. 17 Jun 1903 [
=>
]
11
Benjamin Fairbanks
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.4.5]
b. 17 Feb 1808 d. 7 Oct 1876
Eunice Mead
b. 14 Jan 1811 d. 20 Aug 1893
12
Frances Adelia Fairbanks
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.4.5.1]
b. 10 Mar 1832
12
Anna Fairbanks
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.4.5.2]
b. 7 Sep 1833
12
Esther Fairbanks
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.4.5.3]
b. 9 Mar 1835
12
Samuel Fairbanks
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.4.5.4]
b. 21 Mar 1837 d. 27 Sep 1881 [
=>
]
12
Alfred Fairbanks
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.4.5.5]
b. 2 Jun 1839 d. 6 May 1864
12
Sarah Melissa Fairbanks
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.4.5.6]
b. 9 Aug 1843 d. 1921 [
=>
]
12
Charles B Fairbanks
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.4.5.7]
b. 22 Sep 1846 [
=>
]
12
James Alonzo Fairbanks
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.4.5.8]
b. 14 Feb 1849 [
=>
]
11
Rachel Fairbanks
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.4.6]
b. 5 Jan 1810 d. Bef 1825
11
Reuben Fairbanks
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.4.7]
b. 2 Jun 1811 d. Bef 1825
11
Abbie Fairbanks
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.4.8]
b. Abt 1816
11
Charles Fairbanks
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.4.9]
b. 9 Mar 1817 d. 22 Oct 1869
Hanna Smith
b. Abt 1829
12
Delilah Fairbanks
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.4.9.1]
b. 1839
12
Esther Fairbanks
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.4.9.2]
b. 15 Dec 1841 d. 4 May 1912
12
Orlando Fairbanks
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.4.9.3]
b. 28 Dec 1842 d. 13 Feb 1871
12
Samuel Fairbanks
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.4.9.4]
b. 1844 d. 19 Feb 1923
12
Alice J Fairbanks
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.4.9.5]
b. 14 Apr 1847 d. 14 Feb 1897 [
=>
]
12
Benjamin Fairbanks
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.4.9.6]
b. 3 Dec 1848 d. 3 Feb 1925
12
Abbey D Fairbanks
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.4.9.7]
b. 4 Feb 1851 d. 4 Nov 1860
12
Sibyl Fairbanks
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.4.9.8]
b. 30 Jun 1852 d. 30 Aug 1852
12
Libbie Fairbanks
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.4.9.9]
b. 1856
12
Addie Fairbanks
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.4.9.10]
12
Lee Fairbanks
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.4.9.11]
11
Abigail C Fairbanks
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.4.10]
b. 11 Aug 1825 d. 30 Jun 1848
David R Garrison
b. 1824 d. 1898
12
Mary Garrison
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.4.10.1]
b. 1844 d. 1876
12
Cornelius Garrison
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.4.10.2]
b. Abt 1849 d. 1928
12
Annie Garrison
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.4.10.3]
b. 1853
12
Sarah Ellen Garrison
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.4.10.4]
b. 31 Mar 1856
12
Willie Garrison
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.4.10.5]
b. 1858
12
Bennie Garrison
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.4.10.6]
b. 1860
12
Frank L Garrison
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.4.10.7]
b. 25 May 1862
12
Georgianne Garrison
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.4.10.8]
b. 11 Oct 1869 [
=>
]
10
Benjamin Holbrook
[1.6.3.1.6.1.9.9.8.5]
b. 31 Jan 1786
9
Prudence Darling
[1.6.3.1.6.1.9.9.9]
b. 28 Sep 1757 d. 1827
9
Benjamin Darling
[1.6.3.1.6.1.9.9.10]
b. 28 Feb 1766 d. Bef 14 Apr 1776
7
Lydia White
[1.6.3.1.6.1.10]
b. 10 May 1686
7
Thomas White
[1.6.3.1.6.1.11]
b. 26 Nov 1688 d. 10 Nov 1746
7
Hannah White
[1.6.3.1.6.1.12]
b. 9 Dec 1691 d. Abt 1761
7
Mary White
[1.6.3.1.6.1.13]
b. 1692 d. 1707
7
Abigail White
[1.6.3.1.6.1.14]
b. 10 Nov 1693 d. Bef 22 Mar 1720
7
Rachel White
[1.6.3.1.6.1.15]
b. 27 Dec 1694
6
Thomas White
[1.6.3.1.6.2]
b. 8 May 1680 d. 31 Mar 1762
6
Cornelius White
[1.6.3.1.6.3]
b. 28 Mar 1682 d. 21 Jan 1755
6
Benjamin White
[1.6.3.1.6.4]
b. 12 Oct 1684 d. 12 May 1724
6
Eleazar White
[1.6.3.1.6.5]
b. 8 Nov 1686 d. 14 Apr 1737
6
Ebenezer White
[1.6.3.1.6.6]
b. 3 Aug 1691 d. 18 May 1733
5
Isaac Hunt
[1.6.3.1.7]
b. Abt 1647 d. 12 Dec 1680
3
Mary Best
[1.6.4]
c. 14 Aug 1586 d. 1615
3
Elizabeth "Bridget" Best
[1.6.5]
b. 9 Apr 1592 d. Nov 1638
Abraham Shaw
b. 2 Jan 1590 d. 2 Nov 1638
4
Susanna Grace Shaw
[1.6.5.1]
b. 15 Aug 1621 d. 21 Aug 1698
Nicholas Byram
b. Abt 1610 d. 13 Apr 1688
5
Abagail Byram
[1.6.5.1.1]
b. 1632 d. 1712
5
Experience Byram
[1.6.5.1.2]
b. 1637 d. 1712
5
Deliverance Byram
[1.6.5.1.3]
b. 1638 d. 30 Sep 1720
John Porter
b. 1638 d. 7 Aug 1717
6
Thomas Porter
[1.6.5.1.3.1]
b. 1660 d. Abt 1754
6
Mary Porter
[1.6.5.1.3.2]
b. 22 Oct 1662 d. 24 Dec 1746
Wiliam Petty
b. 12 May 1661 d. 6 Jun 1728
7
Mary Petty
[1.6.5.1.3.2.1]
b. Abt 1690 d. 1756
7
Nathanial Petty
[1.6.5.1.3.2.2]
b. 14 Jun 1691 d. 17 Aug 1747
Mary Stowell
b. 17 Nov 1693 d. 20 Apr 1740
8
William Petty
[1.6.5.1.3.2.2.1]
b. 14 Sep 1715 d. 1753
Abigail Cox
b. 31 Jan 1722
9
William Petty
[1.6.5.1.3.2.2.1.1]
b. 23 Feb 1742
9
Joseph
[1.6.5.1.3.2.2.1.2]
b. Abt 1742
9
James Petty
[1.6.5.1.3.2.2.1.3]
b. 29 Aug 1745 d. 27 Jan 1764
9
Betty Petty
[1.6.5.1.3.2.2.1.4]
b. 31 Dec 1746 d. 1793
Jonathan Hadlock
b. 14 Jul 1742 d. 1801
10
Abigail Hadlock
[1.6.5.1.3.2.2.1.4.1]
b. 19 Mar 1769 d. 4 Apr 1769
10
Samuel Hadlock
[1.6.5.1.3.2.2.1.4.2]
b. 18 Jun 1770
10
Hezekiah Hadlock
[1.6.5.1.3.2.2.1.4.3]
b. 10 Aug 1772 d. 12 Dec 1855
10
Jonathan Hadlock
[1.6.5.1.3.2.2.1.4.4]
b. 28 Aug 1774
10
Joseph Hadlock
[1.6.5.1.3.2.2.1.4.5]
b. 4 Mar 1777 d. 4 Jun 1849
10
Elizabeth "Betsey" Hadlock
[1.6.5.1.3.2.2.1.4.6]
b. 24 Mar 1779 d. 1832
10
Peter Hadlock
[1.6.5.1.3.2.2.1.4.7]
b. 16 Sep 1781
10
Mariam Hadlock
[1.6.5.1.3.2.2.1.4.8]
b. 2 Mar 1784 d. 29 Jun 1851
10
Rhoda Hadlock
[1.6.5.1.3.2.2.1.4.9]
b. Feb 1786
10
Stephan A Hadlock
[1.6.5.1.3.2.2.1.4.10]
b. 12 Feb 1790 d. 9 Sep 1847
Sally Alton
b. 23 Nov 1796 d. 29 Feb 1880
11
Lucretia Hadlock
[1.6.5.1.3.2.2.1.4.10.1]
b. 17 Oct 1817 d. 1889
11
Persina Hadlock
[1.6.5.1.3.2.2.1.4.10.2]
b. 7 Dec 1819 d. Jul 1856
11
Irene Hadlock
[1.6.5.1.3.2.2.1.4.10.3]
b. 21 Aug 1822 d. 17 Nov 1903
11
Hathron Chauncey Hadlock
[1.6.5.1.3.2.2.1.4.10.4]
b. 25 May 1824 d. 3 Oct 1902
11
Oren Alton Hadlock
[1.6.5.1.3.2.2.1.4.10.5]
b. 11 Apr 1826 d. 1 Mar 1892
11
Chastina Hadlock
[1.6.5.1.3.2.2.1.4.10.6]
b. 2 Apr 1828 d. 20 Mar 1913
11
Rosina Hadlock
[1.6.5.1.3.2.2.1.4.10.7]
b. 15 Nov 1831 d. 3 Oct 1884
11
Sally Cecelia Hadlock
[1.6.5.1.3.2.2.1.4.10.8]
b. 23 Sep 1836 d. 30 Jun 1895
William James Hill
b. 3 Mar 1833 d. 26 Dec 1910
12
Stephen William Hill
[1.6.5.1.3.2.2.1.4.10.8.1]
b. 27 Nov 1855 d. 27 Nov 1855
12
Mary Elizabeth Hill
[1.6.5.1.3.2.2.1.4.10.8.2]
b. 2 Mar 1857 d. 2 Mar 1857
12
Sally Lovina Hill
[1.6.5.1.3.2.2.1.4.10.8.3]
b. 25 Feb 1858 d. 29 May 1934 [
=>
]
12
James Henry Hill
[1.6.5.1.3.2.2.1.4.10.8.4]
b. 20 Feb 1860 d. 5 Jan 1917 [
=>
]
12
Sarah Melvina Hill
[1.6.5.1.3.2.2.1.4.10.8.5]
b. 1 Apr 1862 d. 24 Mar 1892 [
=>
]
12
Henretta Augusta Hill
[1.6.5.1.3.2.2.1.4.10.8.6]
b. 28 Nov 1864 d. 4 Sep 1922 [
=>
]
12
George Richard Hill
[1.6.5.1.3.2.2.1.4.10.8.7]
b. 18 Mar 1866 d. 16 Sep 1905 [
=>
]
12
Rozina Emeline Hill
[1.6.5.1.3.2.2.1.4.10.8.8]
b. 23 Jul 1868 d. 4 Apr 1930 [
=>
]
12
Nancy Naomi Hill
[1.6.5.1.3.2.2.1.4.10.8.9]
b. 13 Feb 1873 d. 4 Mar 1930 [
=>
]
12
Rhoda Christina Hill
[1.6.5.1.3.2.2.1.4.10.8.10]
b. 16 Apr 1875 d. 16 Apr 1926 [
=>
]
12
Adeline Precinda Hill
[1.6.5.1.3.2.2.1.4.10.8.11]
b. 3 Jun 1878 d. 1 Jun 1926 [
=>
]
12
Louella Cilicia Hill
[1.6.5.1.3.2.2.1.4.10.8.12]
b. 15 Aug 1880 d. 15 Aug 1880
11
Esther Adeline Hadlock
[1.6.5.1.3.2.2.1.4.10.9]
b. 12 Feb 1841 d. 20 Dec 1913
11
Henrietta Hadlock
[1.6.5.1.3.2.2.1.4.10.10]
b. 10 Jul 1843 d. 8 Aug 1928
William James Hill
b. 3 Mar 1833 d. 26 Dec 1910
12
Sally Lodedkia Hill
[1.6.5.1.3.2.2.1.4.10.10.1]
b. 28 Aug 1868 d. 29 Sep 1869
12
Rosetha Amena Hill
[1.6.5.1.3.2.2.1.4.10.10.2]
b. 10 Apr 1870 d. 10 Apr 1909
12
Emily Cilicia Hill
[1.6.5.1.3.2.2.1.4.10.10.3]
b. 4 Aug 1871 d. 30 Apr 1949 [
=>
]
12
Cynthia Clista Hill
[1.6.5.1.3.2.2.1.4.10.10.4]
b. 19 Jul 1873 d. 31 Oct 1946 [
=>
]
12
Charles Sylvester Hill
[1.6.5.1.3.2.2.1.4.10.10.5]
b. 11 Oct 1874 d. 15 Feb 1960
12
Ester Marinda Hill
[1.6.5.1.3.2.2.1.4.10.10.6]
b. 20 Aug 1876 d. 28 Oct 1900 [
=>
]
12
Zina Belinda Hill
[1.6.5.1.3.2.2.1.4.10.10.7]
b. 11 Oct 1877 d. 16 Feb 1965 [
=>
]
12
Henrietta Persina Hill
[1.6.5.1.3.2.2.1.4.10.10.8]
b. 16 Jul 1879 d. 11 Jun 1961
12
Hulda Carinda Hill
[1.6.5.1.3.2.2.1.4.10.10.9]
b. 19 Oct 1881 d. 24 Mar 1953 [
=>
]
12
Betty Petty Hill
[1.6.5.1.3.2.2.1.4.10.10.10]
b. 4 Sep 1884 d. 18 Jun 1917 [
=>
]
12
William Strait Hill
[1.6.5.1.3.2.2.1.4.10.10.11]
b. 23 Feb 1886 d. 2 Jan 1985 [
=>
]
10
Amos Ward Hadlock
[1.6.5.1.3.2.2.1.4.11]
b. 6 Apr 1793
8
Nathanial Petty
[1.6.5.1.3.2.2.2]
b. 6 Aug 1718 d. 20 Apr 1740
8
Thomas Petty
[1.6.5.1.3.2.2.3]
b. 5 Feb 1721 d. Aft 1751
8
John Petty
[1.6.5.1.3.2.2.4]
b. 23 Mar 1725 d. 17 Aug 1747
8
Mary Petty
[1.6.5.1.3.2.2.5]
b. 10 Mar 1729
8
Sarah Petty
[1.6.5.1.3.2.2.6]
b. 9 Sep 1732
8
Ruth Petty
[1.6.5.1.3.2.2.7]
b. 30 Jun 1742
7
Thomas Petty
[1.6.5.1.3.2.3]
b. 1692 d. 9 Nov 1716
7
Ruth Petty
[1.6.5.1.3.2.4]
b. Abt 1694 d. 15 Sep 1738
7
John Petty
[1.6.5.1.3.2.5]
b. 1696 d. 4 Sep 1716
7
Deliverance Petty
[1.6.5.1.3.2.6]
b. 1698 d. 21 Aug 1802
6
Susanna Porter
[1.6.5.1.3.3]
b. 2 Jun 1665 bur. 1761
6
Sergeant John Porter
[1.6.5.1.3.4]
b. 2 Jul 1667 d. 22 May 1723
6
Samuel Byram Porter
[1.6.5.1.3.5]
b. 20 Mar 1670 d. 31 Aug 1725
6
Nicholas Porter
[1.6.5.1.3.6]
b. 11 Apr 1672 d. 31 Dec 1773
6
Lieutenant Ebenezer Porter
[1.6.5.1.3.7]
b. Abt 1674 d. 1763
6
Ruth Porter
[1.6.5.1.3.8]
b. 18 Sep 1676 d. Aft 1739
6
Sarah Porter
[1.6.5.1.3.9]
b. 1680 d. 3 Mar 1741
5
Nicholas Byram
[1.6.5.1.4]
b. 1640 d. 20 Sep 1727
5
Mary Byram
[1.6.5.1.5]
b. 16 Sep 1646 d. Aft 1709
5
Susanna Byram
[1.6.5.1.6]
b. 1648 d. 12 Mar 1742
4
Joseph Shaw
[1.6.5.2]
b. 14 Mar 1618 d. 13 Dec 1653
4
Grace Shaw
[1.6.5.3]
b. 15 Aug 1621 d. 21 Aug 1698
4
Martha Shaw
[1.6.5.4]
b. 1 Dec 1623 d. 31 Mar 1625
4
Abigail Shaw
[1.6.5.5]
b. 1626
4
Maria "Mary" Shaw
[1.6.5.6]
b. 18 Jun 1626 d. 25 Mar 1658
4
John Shaw
[1.6.5.7]
b. 2 Mar 1629 d. 30 Jul 1701