Home Page
|
What's New
|
Photos
|
Histories
|
Headstones
|
Reports
|
Surnames
Search
First Name:
Last Name:
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Suomalainen
Svenska
John Field
Abt 1535 - 1615 (80 years)
Submit Photo / Document
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Submit Photo / Doc
Worksheet
Family
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
John Field
[1]
b. Abt 1535 d. 24 Nov 1615
Grace Turner
b. 1555 d. 5 Jun 1612
2
Abiah Field
[1.1]
b. 21 May 1577
+
Elkanah Nashe
2
Martha Field
[1.2]
b. 16 Feb 1579 d. 24 Oct 1663
Thomas Deacon
b. 1570 d. 24 Oct 1663
3
Phebe Deacon
[1.2.1]
b. 3 Apr 1597 d. 20 Sep 1663
Zaccheus Gould
b. 1 Oct 1589 d. 30 Mar 1668
4
Phebe Gould
[1.2.1.1]
b. 27 Sep 1620 d. 7 May 1686
Thomas Perkins
b. 28 Apr 1622 d. 7 May 1686
5
John Perkins
[1.2.1.1.1]
b. Abt 1641 d. 19 May 1688
Deborah Browning
c. 31 Jan 1646 d. Aft 1704
6
Thomas Perkins
[1.2.1.1.1.1]
b. 4 May 1667 d. 3 Jun 1709
5
Phebe Perkins
[1.2.1.1.2]
b. 1644 d. 1680
Jacob Towne
c. 11 Mar 1632 d. 20 Feb 1713
6
Phebe Towne
[1.2.1.1.2.1]
b. 4 May 1666 d. 3 Jan 1669
6
Joanna Towne
[1.2.1.1.2.2]
b. 22 Jan 1668 d. 1736
+
Thomas Nichols
b. 20 Jan 1670 d. Aft 1725
6
Mary Towne
[1.2.1.1.2.3]
b. 27 Mar 1670 d. Aft 1695
+
Isaac Larrabee
b. 1663 d. May 1755
6
Susanna Towne
[1.2.1.1.2.4]
b. 24 Dec 1671 d. 13 Sep 1766
John Cummings
b. 7 Jun 1666 d. 3 Jul 1706
7
Joseph Cummings
[1.2.1.1.2.4.1]
b. Jan 1689 d. 22 Apr 1794
7
Sarah Cummings
[1.2.1.1.2.4.2]
b. 30 May 1690 d. Aft 1728
7
John Cummings
[1.2.1.1.2.4.3]
b. 12 Jun 1692
7
Isaac Cummings
[1.2.1.1.2.4.4]
b. 25 Dec 1695 d. Abt 1752
7
David Cummings
[1.2.1.1.2.4.5]
b. 15 Apr 1698 d. 2 Apr 1765
7
Mary Cummings
[1.2.1.1.2.4.6]
b. 13 May 1700 d. Bef 1732
7
Susannah Cummings
[1.2.1.1.2.4.7]
b. 13 Jan 1702 d. 1723
7
Hannah Cummings
[1.2.1.1.2.4.8]
c. 21 Dec 1718 d. 1718
6
Joseph Towne
[1.2.1.1.2.5]
b. 22 Mar 1673 d. 28 May 1757
6
Sarah Towne
[1.2.1.1.2.6]
b. 30 Dec 1675 d. 1 Nov 1760
6
John Towne
[1.2.1.1.2.7]
b. 20 Feb 1678 d. 28 Mar 1714
Abigail Stanley
b. 6 Aug 1688 d. 1 Sep 1743
7
John Towne
[1.2.1.1.2.7.1]
b. 5 Dec 1729 d. 9 Jan 1820
7
Abigail Towne
[1.2.1.1.2.7.2]
b. 29 Sep 1721 d. 8 Dec 1739
7
Catherine Towne
[1.2.1.1.2.7.3]
b. 14 Dec 1725
7
Bartholemew Towne
[1.2.1.1.2.7.4]
b. 4 Apr 1713 d. 9 May 1783
7
Samuel Towne
[1.2.1.1.2.7.5]
b. 1717 d. Nov 1778
7
Johnathan Towne
[1.2.1.1.2.7.6]
b. 5 Dec 1729 bur. Jul 1771
6
Martha Towne
[1.2.1.1.2.8]
b. 19 May 1680 d. 24 Feb 1753
+
Isaac Leach
b. Abt 1676
6
Phebe Towne
[1.2.1.1.2.9]
b. 23 Jul 1685 d. 10 Jun 1736
John Gould
b. 25 Aug 1687 d. 20 Jul 1762
7
John Gould
[1.2.1.1.2.9.1]
b. 9 Apr 1712 d. 18 Apr 1712
7
Kezia Gould
[1.2.1.1.2.9.2]
b. 10 May 1718 d. 28 Dec 1798
7
Stephen Gould
[1.2.1.1.2.9.3]
b. 6 Jul 1724 d. 1798
7
Ruth Gould
[1.2.1.1.2.9.4]
b. 16 Sep 1727 d. Not Needed
7
Esther Gould
[1.2.1.1.2.9.5]
b. 10 Aug 1732 d. 1785
5
Zaccheus Perkins
[1.2.1.1.3]
b. 1647 d. 1 Dec 1732
5
Thomas Perkins
[1.2.1.1.4]
b. Abt 1648 d. Apr 1722
Sarah Wallis
b. 24 Jul 1658 d. 1719
6
Thomas Perkins
[1.2.1.1.4.1]
b. 9 Dec 1688
6
Hannah Perkins
[1.2.1.1.4.2]
b. 1690 d. 1 Jan 1747
6
Robert Perkins
[1.2.1.1.4.3]
b. Abt 1695 d. 15 Jan 1750
6
Samuel Perkins
[1.2.1.1.4.4]
b. 18 May 1712 d. 1 Jan 1747
5
Martha Perkins
[1.2.1.1.5]
b. 1649 d. Abt 1728
John Lamson
b. Nov 1642 d. Bef 23 Jun 1717
6
John Lamson, Jr
[1.2.1.1.5.1]
b. 21 Nov 1669 d. 1 Sep 1760
6
Phebe Lamson
[1.2.1.1.5.2]
b. 13 Aug 1673 d. 23 May 1753
6
William Lamson
[1.2.1.1.5.3]
b. 19 Aug 1675 d. 1750
6
Martha Lamson
[1.2.1.1.5.4]
b. 21 Aug 1677 d. Abt 1724
6
Thomas Lamson
[1.2.1.1.5.5]
b. 3 Jan 1682 d. Jul 1767
6
Samuel Lamson
[1.2.1.1.5.6]
b. 25 Feb 1684 d. 17 Nov 1760
5
Mary Perkins
[1.2.1.1.6]
b. 1651 d. 1728
William Howlet
b. Abt 1650 d. 1718
6
John Howlet
[1.2.1.1.6.1]
b. Abt 1676 d. 7 Sep 1735
5
Judith Perkins
[1.2.1.1.7]
b. 11 Jul 1655 d. Abt 1743
Nathaniel Browne
b. 1645 bur. 13 Sep 1717
6
Nathaniel Brown
[1.2.1.1.7.1]
b. Abt 1676 d. Abt 12 Feb 1759
6
Elizabeth Brown
[1.2.1.1.7.2]
b. Abt 1678 d. Bef 1716
5
Elisha Perkins
[1.2.1.1.8]
b. 1656 d. 18 Feb 1741
Catharine Towne
b. 25 Feb 1662 d. 2 Jul 1714
6
Thomas Perkins
[1.2.1.1.8.1]
b. 15 Oct 1681 d. 1761
6
Elisha Perkins
[1.2.1.1.8.2]
b. 27 May 1683 d. 24 Dec 1704
6
John Perkins
[1.2.1.1.8.3]
b. 12 Aug 1685 d. 22 Jun 1750
6
Catharina Perkins
[1.2.1.1.8.4]
c. 3 Feb 1687
6
Phebe Perkins
[1.2.1.1.8.5]
b. 10 Aug 1690
6
Jacob B Perkins
[1.2.1.1.8.6]
c. 13 Nov 1692 d. 18 Nov 1758
6
Ruth Perkins
[1.2.1.1.8.7]
c. 10 May 1695 d. 9 Jun 1695
6
Mary Perkins
[1.2.1.1.8.8]
b. 30 Mar 1699 d. 1737
6
Joseph Perkins
[1.2.1.1.8.9]
b. 10 May 1702 d. 1777
5
Timothy Perkins
[1.2.1.1.9]
b. 6 Jun 1661 d. 18 Dec 1751
4
Mary Gould
[1.2.1.2]
b. 12 Dec 1621 d. 15 Nov 1690
John Reddington
b. Abt 1617 d. 15 Nov 1690
5
Daniel Reddingtion
[1.2.1.2.1]
b. 1645 d. 28 Sep 1732
5
Eliza Reddington
[1.2.1.2.2]
b. 1648
5
John Reddington
[1.2.1.2.3]
b. 20 Jun 1649 d. 8 Mar 1650
5
Mary Reddington
[1.2.1.2.4]
b. 4 May 1651 d. 13 Mar 1682
5
Phebe Reddington
[1.2.1.2.5]
b. 7 Apr 1655 d. 1 Oct 1696
5
Martha Reddington
[1.2.1.2.6]
b. 7 Apr 1655 d. 7 Aug 1731
5
Sarah Reddington
[1.2.1.2.7]
c. 12 Mar 1658 d. 8 Jul 1689
4
Martha Gould
[1.2.1.3]
b. 19 Jun 1623 d. Abt 1699
John Newmarch
b. 1619 d. 7 Mar 1696
5
John Newmarch
[1.2.1.3.1]
b. Abt 1649 d. 21 May 1733
5
Thomas Newmarch
[1.2.1.3.2]
b. Abt 1651 d. 9 Jul 1716
5
Sara Newmarch
[1.2.1.3.3]
b. Abt 1652 d. 1751
5
Phebe Newmarch
[1.2.1.3.4]
b. Abt 1652
5
Martha Newmarch
[1.2.1.3.5]
b. Abt 1652 d. 7 Jul 1720
5
Zaccheus Neumarch
[1.2.1.3.6]
b. Abt 1653 d. 1731
4
Priscilla Gould
[1.2.1.4]
b. 27 Sep 1628 d. 16 Sep 1663
John Wildes
b. 1620 d. 14 May 1705
5
Sarah Wildes
[1.2.1.4.1]
b. 1647 d. 12 May 1711
5
Elizabeth Wildes
[1.2.1.4.2]
b. 1653 d. 25 Jun 1718
Lieutenant Benjamin Jones
b. 31 Jul 1651 d. 25 Jun 1718
6
Lieutenant Thomas Jones
[1.2.1.4.2.1]
b. 13 Mar 1680 d. 4 Nov 1763
Mary Meacham
b. 12 Jan 1684 d. 8 Nov 1744
7
Mary Jones
[1.2.1.4.2.1.1]
b. 22 Apr 1709 d. 4 Nov 1780
Abraham Whipple
b. Abt 1709 d. 3 Oct 1768
8
Bathsheba Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.1]
b. 2 Feb 1731
8
Abraham Whipple, Jr
[1.2.1.4.2.1.1.2]
b. 18 Mar 1734
8
Mary Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.3]
b. 1 Mar 1735 d. 6 Dec 1823
8
Samuel Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.4]
b. 7 Jan 1737 d. 28 Sep 1762
+
Oliver Evans
b. Abt 1741
8
Joseph Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.5]
b. 18 May 1740
Abigail Gary
b. 2 Jul 1743
9
Abraham Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.5.1]
b. 11 Feb 1768 d. 12 Jan 1852
8
Luther Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6]
b. 7 Mar 1743 d. 1830
Eunice Gates
b. Abt 1744
9
Abram Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1]
b. 11 Feb 1768 d. 12 Jan 1852
Asenath Sumner
b. 2 Aug 1768 d. 23 Dec 1851
10
Abigail Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.1]
b. 1794 d. 13 Apr 1870
Isaac Coon
b. 25 Apr 1792 d. 5 Jan 1878
11
Lucinda Coon
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.1.1]
b. 1815 d. 7 Apr 1881
10
Louisa Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.2]
b. 1798 d. 12 Apr 1889
10
Eunice Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.3]
b. 1800
10
Daniel Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.4]
b. 20 Nov 1801 d. 26 Apr 1889
Maria Chamberlain
b. 9 Aug 1825 d. 31 Dec 1891
11
Jane Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.4.1]
b. 14 Nov 1850 d. 19 Jul 1932
11
Jerome Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.4.2]
b. 17 Mar 1853 d. 17 Nov 1921
11
Abraham Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.4.3]
b. May 1863
11
Elizabeth Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.4.4]
b. 1866 d. 1937
11
Sarah Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.4.5]
b. 23 Feb 1869 d. 24 Apr 1895
10
Asenath "Sena" Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.5]
b. 1803 d. 27 May 1896
Lyman Hoyt
b. 1804
11
Lucy Ann Hoyt
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.5.1]
b. Abt 1834 d. 26 Feb 1920
Alexander M Thompson
b. Abt 1825 d. 27 Mar 1882
12
Jennie A Thompson
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.5.1.1]
b. Oct 1858 d. 28 Jun 1900
12
Asenath J Thompson
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.5.1.2]
b. 1859
12
Martha A Thompson
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.5.1.3]
b. 1862
11
Mary Hoyt
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.5.2]
b. Abt 1836
11
Sarah Hoyt
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.5.3]
b. Abt 1838
11
Lois Hoyt
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.5.4]
b. Abt 1844 d. Bef 1860
11
Esther Hoyt
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.5.5]
b. Abt 1846
11
Henry V Hoyt
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.5.6]
b. 27 Feb 1850 d. 10 Sep 1933
10
Lydia Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.6]
b. 1806 d. 19 Sep 1880
Jacob Mead
b. 3 Aug 1807 d. 14 Oct 1880
11
Aseneth Mead
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.6.1]
b. 17 Dec 1831 d. 29 Apr 1844
10
Henry Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.7]
b. 22 May 1807 d. 13 Jan 1895
Polly Ellis
b. 22 Mar 1816
11
Harrison Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.7.1]
b. 1835
11
Gardner C Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.7.2]
b. 12 Aug 1849 d. 25 Sep 1926
11
Betsey Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.7.3]
b. 1850
11
Caroline Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.7.4]
b. 1851
11
Adelbert Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.7.5]
b. Oct 1854 d. 1936
11
Warren Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.7.6]
b. Aug 1863 d. 25 Apr 1915
+
Margaret Bertha Tracy
b. 1870
10
George "Leo" Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.8]
b. 18 May 1809 d. 19 Jul 1896
Sarah Maritta Stratter
b. 9 Jan 1811 d. 31 Aug 1889
11
Mary E Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.8.1]
b. Feb 1838 d. 11 Feb 1917
Hiram Knickerbocker Mott
b. 18 May 1838 d. 5 May 1914
12
George W Mott
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.8.1.1]
b. 13 Oct 1859 [
=>
]
12
John Stratton Mott
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.8.1.2]
b. 30 Jun 1863 d. 13 Sep 1933
12
Sarah M Mott
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.8.1.3]
b. 24 May 1866 [
=>
]
12
Omar D Mott
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.8.1.4]
b. 9 Feb 1870 d. 5 Jun 1914
12
Hezekiah H Mott
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.8.1.5]
b. 17 Jun 1872
12
Andrew C Mott
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.8.1.6]
b. 4 Apr 1874 d. 11 Jul 1957
12
Kiah C Mott
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.8.1.7]
b. 17 Jun 1876
11
Jonathan S Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.8.2]
b. 1840 d. 1933
11
Judson A Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.8.3]
b. 9 Jul 1847 d. 25 Jan 1931
Helen A Morse
b. 12 Sep 1846 d. 11 Dec 1922
12
Clara Mae Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.8.3.1]
b. 6 Jan 1871 d. 20 Apr 1962
12
Frederick Warren Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.8.3.2]
b. 2 Nov 1873 d. 9 Apr 1952
12
Eliza Marietta Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.8.3.3]
b. 13 Sep 1875 d. 30 Oct 1911
12
Arthur J Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.8.3.4]
b. 25 Mar 1877 d. 25 Mar 1955
12
Nettie E Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.8.3.5]
b. 24 Jan 1879 bur. 1931
12
George S Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.8.3.6]
b. 13 May 1880 d. 2 Dec 1963
12
Lena "Nora" Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.8.3.7]
b. 16 Nov 1883 d. 3 Aug 1973
11
Daniel Burdette Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.8.4]
b. 1853 d. 1922
10
Abraham Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.9]
b. 1810 d. Abt 1888
Catherine Smith
b. Oct 1819 d. Aft 1900
11
Isaac Conrad Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.9.1]
b. 4 Mar 1838 d. 24 May 1927
Margaret Catherine Falkner
b. 27 May 1843 d. 5 Dec 1917
12
Abraham Lincoln "Abegiell" Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.9.1.1]
b. 15 Sep 1865 d. 10 May 1940 [
=>
]
12
Caroline Bertha Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.9.1.2]
b. 13 Dec 1866 d. 16 Apr 1946 [
=>
]
12
Charles A Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.9.1.3]
b. 26 Jan 1868 d. 1927
12
John Peter Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.9.1.4]
b. 18 Oct 1869 d. 16 Jul 1955 [
=>
]
12
Idella "Ida" Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.9.1.5]
b. 9 Aug 1871 d. 1950
12
George William Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.9.1.6]
b. 8 Sep 1872 d. 20 Mar 1929 [
=>
]
12
Albert A "Bert" Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.9.1.7]
b. 6 Aug 1875 d. 1945
12
Mary Ann Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.9.1.8]
b. 21 Sep 1877 d. 19 Aug 1942 [
=>
]
12
Margaret Carrie Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.9.1.9]
b. 19 Feb 1880 d. 19 Feb 1929
11
Agnes Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.9.2]
b. May 1839 d. 1930
11
Catherine Minerva Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.9.3]
b. 1840
Frailand Morehouse
b. 1832
12
Son Morehouse
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.9.3.1]
b. 1860
12
Ina Morehouse
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.9.3.2]
b. 1880
11
Alena Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.9.4]
b. 1841
11
Julia Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.9.5]
b. 1843
11
Richard Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.9.6]
b. 1845
Phebe Woolheater
b. 1842 d. 1910
12
Frederick Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.9.6.1]
b. 1867 d. 19 Mar 1945
12
Henry Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.9.6.2]
b. 1872
12
Francis Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.9.6.3]
b. 1879
+
Joanna Green
b. 1860 d. 1936
11
Abraham Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.9.7]
b. 1847
11
Lavinda Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.9.8]
b. 1853 d. 10 Oct 1878
11
Ida Jane Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.9.9]
b. Abt 1858
11
George B Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.9.10]
b. Abt 1862
11
Abby Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.9.11]
b. Abt 1874
10
Caroline Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.10]
b. 1811
10
Jane Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.1.11]
b. 1812 d. 3 Aug 1872
9
Eunice Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.2]
b. 18 Mar 1770 d. 26 Feb 1863
9
Polly Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.3]
b. 1772 d. 24 Aug 1847
Thomas Whittlesey
b. 28 Feb 1772 d. 2 Mar 1847
10
Lucy Whittlesey
[1.2.1.4.2.1.1.6.3.1]
b. Jun 1797 d. Jul 1865
10
Maria Whittlesey
[1.2.1.4.2.1.1.6.3.2]
b. 9 Apr 1805
10
Eliza Whittlesey
[1.2.1.4.2.1.1.6.3.3]
b. 19 Aug 1807 d. Abt 1831
George Peck
b. 1810
11
Nancy Maria Peck
[1.2.1.4.2.1.1.6.3.3.1]
b. 30 May 1833 d. 8 Jul 1911
Charles Giles Myers
b. 16 Mar 1830 d. 1 Jun 1910
12
Eureka N Myers
[1.2.1.4.2.1.1.6.3.3.1.1]
b. 1857
12
Charles Chester Myers
[1.2.1.4.2.1.1.6.3.3.1.2]
b. 6 May 1858 d. 12 Feb 1944 [
=>
]
12
Alma Alfaretta Myers
[1.2.1.4.2.1.1.6.3.3.1.3]
b. 10 Nov 1872 d. 8 Sep 1952 [
=>
]
10
Thomas Jefferson Whittlesey
[1.2.1.4.2.1.1.6.3.4]
b. 13 Jun 1812
10
Isaac Whittlesey
[1.2.1.4.2.1.1.6.3.5]
b. 25 Mar 1815
Adelaide Shailor
b. 13 Sep 1819 d. 18 Feb 1856
11
Josephine Ann Whittlesey
[1.2.1.4.2.1.1.6.3.5.1]
b. 28 Apr 1847 d. 2 Mar 1850
11
Charles Chester Whittlesey
[1.2.1.4.2.1.1.6.3.5.2]
b. 28 Nov 1851
11
Adelaide Maria Whittlesey
[1.2.1.4.2.1.1.6.3.5.3]
b. 28 Jan 1855
+
Charles Parks
b. Abt 1851
10
Francis Elmira Whittlesey
[1.2.1.4.2.1.1.6.3.6]
b. 30 Sep 1817
9
Elizabeth Gates Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.4]
b. 19 Aug 1775 d. 26 Jun 1862
John Sawyer
b. 10 May 1773 d. 21 Apr 1871
10
Abraham Sawyer
[1.2.1.4.2.1.1.6.4.1]
b. 1 Feb 1796 d. 9 Apr 1868
10
John Sawyer
[1.2.1.4.2.1.1.6.4.2]
b. 14 Apr 1805 d. 26 Feb 1880
Elizabeth Quick
b. 15 May 1807 d. 1901
11
Lewis Sawyer
[1.2.1.4.2.1.1.6.4.2.1]
b. 23 Aug 1825
11
Hiram Sawyer
[1.2.1.4.2.1.1.6.4.2.2]
b. 26 Jun 1826 d. 14 Mar 1913
+
Phoebe Jane Teed
b. 23 Aug 1829 d. 6 Mar 1908
11
Sarah A Sawyer
[1.2.1.4.2.1.1.6.4.2.3]
b. 24 Sep 1837 d. 30 Nov 1918
William Dunham
b. 11 Aug 1837 d. 20 Jun 1886
12
Rose Ann Dunham
[1.2.1.4.2.1.1.6.4.2.3.1]
b. Abt 1865 [
=>
]
12
Wilson C Dunham
[1.2.1.4.2.1.1.6.4.2.3.2]
b. 1873
12
Nellia Dunham
[1.2.1.4.2.1.1.6.4.2.3.3]
b. 1875
10
Issac Sawyer
[1.2.1.4.2.1.1.6.4.3]
b. 3 Sep 1816 d. 1 Jul 1912
10
Ira Sawyer
[1.2.1.4.2.1.1.6.4.4]
b. 3 Sep 1816 d. 28 Nov 1899
Damaris Burrows
b. 4 Oct 1828 d. 29 Mar 1929
11
Franklin W Sawyer
[1.2.1.4.2.1.1.6.4.4.1]
b. 20 Apr 1855 d. 14 Aug 1941
11
Jasper Sawyer
[1.2.1.4.2.1.1.6.4.4.2]
b. 1857 d. Bef 1870
11
John L Sawyer
[1.2.1.4.2.1.1.6.4.4.3]
b. Oct 1858 d. 25 Jan 1915
Catherine M
b. Jan 1865
12
Charles Leslie
[1.2.1.4.2.1.1.6.4.4.3.1]
b. Aug 1892
11
Luther D Sawyer
[1.2.1.4.2.1.1.6.4.4.4]
b. 1860
Katheryn
b. 1865
12
Maud M Sawyer
[1.2.1.4.2.1.1.6.4.4.4.1]
b. 1893
11
Sarah Sawyer
[1.2.1.4.2.1.1.6.4.4.5]
b. Abt Jun 1862
Frank Blanchard
b. Apr 1870
12
Minna Blanchard
[1.2.1.4.2.1.1.6.4.4.5.1]
b. Aug 1885
12
Amber Lucy Blanchard
[1.2.1.4.2.1.1.6.4.4.5.2]
b. Jul 1889
12
Sadie Blanchard
[1.2.1.4.2.1.1.6.4.4.5.3]
b. Jun 1891
12
Frank Blanchard
[1.2.1.4.2.1.1.6.4.4.5.4]
b. 13 Jan 1893 d. 26 Sep 1975 [
=>
]
12
John Blanchard
[1.2.1.4.2.1.1.6.4.4.5.5]
b. Jan 1896
12
Lena Blanchard
[1.2.1.4.2.1.1.6.4.4.5.6]
b. Mar 1897
12
Earl Blanchard
[1.2.1.4.2.1.1.6.4.4.5.7]
b. 11 Nov 1899 d. 5 Mar 1989
12
Catherine M Blanchard
[1.2.1.4.2.1.1.6.4.4.5.8]
b. 1907
11
Vina Sawyer
[1.2.1.4.2.1.1.6.4.4.6]
b. 1864
11
Frederick W Sawyer
[1.2.1.4.2.1.1.6.4.4.7]
b. 1865
11
Tim Sawyer
[1.2.1.4.2.1.1.6.4.4.8]
b. 1867
11
Simeon F Sawyer
[1.2.1.4.2.1.1.6.4.4.9]
b. 1868
11
Andrew J Sawyer
[1.2.1.4.2.1.1.6.4.4.10]
b. 1869 d. 7 Oct 1935
11
Nancy J Sawyer
[1.2.1.4.2.1.1.6.4.4.11]
b. 1871
11
Jennie Sawyer
[1.2.1.4.2.1.1.6.4.4.12]
b. 1872
11
Jasper Sawyer
[1.2.1.4.2.1.1.6.4.4.13]
b. 1874
9
Lydia Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.5]
b. 1777
9
Martha Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.6]
b. 1781
9
Clarissa Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.7]
b. 11 Mar 1784
Joel Sawyer, Jr
b. 7 Aug 1781 d. 1 Sep 1859
10
Joel W Sawyer
[1.2.1.4.2.1.1.6.7.1]
b. 6 Dec 1815 d. 25 Dec 1908
+
Sarah Ann Moore
b. Abt 1818
+
Saphronie Simmons
b. Abt 1819
9
Henry Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.8]
b. Abt 1785 d. Aft 1800
9
Thomas Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.9]
b. 1787 d. 18 Sep 1887
Cynthia Allen
b. 3 Feb 1788 d. 30 Oct 1861
10
Allen G Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.9.1]
b. 1812 d. Aft 8 Jun 1880
Lydia Cranston
b. 1801 d. 1879
11
Sarah Malvinia Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.9.1.1]
b. 1837
Benjamin Lewis Crosby
b. 22 Jul 1847
12
Addie Lucinda Crosby
[1.2.1.4.2.1.1.6.9.1.1.1]
b. 1871 [
=>
]
12
Arthur Crosby
[1.2.1.4.2.1.1.6.9.1.1.2]
b. 1872 d. 1880
12
Iva Crosby
[1.2.1.4.2.1.1.6.9.1.1.3]
b. 1876
12
Samuel Morrison Crosby
[1.2.1.4.2.1.1.6.9.1.1.4]
b. 21 Sep 1878 [
=>
]
12
Mima Crosby
[1.2.1.4.2.1.1.6.9.1.1.5]
b. Abt 1879 d. 1946 [
=>
]
11
Samuel C Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.9.1.2]
b. 1840
10
Thomas Corbin Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.9.2]
b. 28 Mar 1814 d. 9 Feb 1892
Maria Winner
b. 18 Mar 1811 d. 24 Aug 1891
11
John H Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.9.2.1]
b. 18 Feb 1841 d. Jun 1917
10
Ruth Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.9.3]
b. Abt 1816
10
Abigail Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.9.4]
b. Abt 1818
10
Ira Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.6.9.5]
b. 2 Jan 1820 d. 7 Oct 1895
8
Anna Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.7]
b. 17 Feb 1744 d. 1811
Robert Follett
b. 27 Apr 1739 d. 9 Apr 1810
9
Robert Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.1]
b. 15 Sep 1764
Molly Knap
b. 17 Apr 1766
10
Nancy Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.1.1]
b. Aft 1800
9
Anna Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.2]
b. 22 Mar 1766 d. 23 Apr 1839
Joseph Ford
b. 29 Feb 1768 d. 30 Jan 1846
10
Sarah Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.1]
b. 1793 d. 1842
Nathan Neal
b. 1790
11
Mary Neal
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.1.1]
b. 1813
11
Joseph Neal
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.1.2]
b. 1814
11
Anna Neal
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.1.3]
b. 13 May 1816
Allen Wentworth
b. 7 Oct 1814 d. 11 Mar 1904
12
Abigail Amanda Wentworth
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.1.3.1]
b. 11 Feb 1836 d. 18 Mar 1865 [
=>
]
12
Edward Joseph Wentworth
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.1.3.2]
b. 8 Oct 1837 d. 4 Apr 1863
12
Alice Augusta Wentworth
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.1.3.3]
b. 11 Dec 1843 d. 12 Oct 1867
11
Perley Neal
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.1.4]
b. 1817
11
Fannie Neal
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.1.5]
b. 1818
11
Orrin S Neal
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.1.6]
b. 4 Nov 1819 d. 17 Jan 1903
Elsie E Smith
b. 29 Jan 1828 d. 17 Apr 1911
12
Joseph A Neal
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.1.6.1]
b. 1852
12
Daniel D Neal
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.1.6.2]
b. 12 Jan 1854 d. 15 Nov 1917 [
=>
]
12
Lewis R Neal
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.1.6.3]
b. Jun 1858 d. 25 Feb 1928 [
=>
]
12
Adrian Adelbert Neal
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.1.6.4]
b. 29 Jan 1869 d. 16 Jan 1940 [
=>
]
11
George Neal
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.1.7]
b. 1822
11
Sally Neal
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.1.8]
b. 1825
10
John Perley Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2]
b. 6 Dec 1794 d. 18 Sep 1869
Susanna Catharine Gallman
b. 10 Jul 1803 d. 1862
11
George Washington Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.1]
b. Abt 1813 d. 2 Jan 1913
Mary Ann Richie
b. Abt 1805 d. 24 Mar 1864
12
Robert Joseph Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.1.1]
b. 12 Nov 1830 d. 24 Jan 1899 [
=>
]
12
Catherine Jane Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.1.2]
b. 31 May 1831 d. 18 May 1869 [
=>
]
12
Cynthia Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.1.3]
b. 1833
12
Louisa Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.1.4]
b. 4 May 1835 d. 20 Feb 1901 [
=>
]
12
Phila Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.1.5]
b. 1836
12
George Washington Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.1.6]
b. 14 Aug 1842 d. 15 Aug 1877 [
=>
]
12
Lucina Elizabeth Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.1.7]
b. 7 Apr 1846 d. 11 Nov 1884 [
=>
]
12
Samuel S Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.1.8]
b. 1847 [
=>
]
12
Archelaus Tilly Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.1.9]
b. 14 May 1856 d. 20 Mar 1919 [
=>
]
12
Edna Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.1.10]
b. 14 Nov 1857
12
Jesse Franklin Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.1.11]
b. 10 Mar 1859 d. 1932
12
David Cicero Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.1.12]
b. 14 Sep 1861 d. Aug 1902 [
=>
]
Nancy Ann Anderson
b. 19 Oct 1844 d. 10 Sep 1913
12
Sarah Albino Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.1.13]
b. 2 Oct 1866 d. 18 May 1951 [
=>
]
12
Joseph Perley Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.1.14]
b. 18 Jan 1868 d. 1938 [
=>
]
12
William Erastus Acker Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.1.15]
b. 1 Feb 1870 d. 26 Apr 1936
12
Thomas Noah Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.1.16]
b. 3 Apr 1872 d. 28 Jan 1959
12
Daughter Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.1.17]
b. 1873 d. 1874
12
George Madison Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.1.18]
b. 22 Oct 1874 d. 4 Oct 1953
12
Florence E Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.1.19]
b. 28 Jan 1879 d. Feb 1972 [
=>
]
12
Alvin Elmer Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.1.20]
b. 2 Nov 1882 d. 15 Nov 1966 [
=>
]
11
Joseph Perley Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.2]
b. 25 Jun 1826 d. 1855
Mary Garrett
b. 1830
12
Otis Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.2.1]
b. 1850
12
Myrtle Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.2.2]
b. 1852
11
Jesse Stanley Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.3]
b. 1828
Sarah Farmer
b. 16 Jun 1833 d. 10 Aug 1905
12
Susannah K Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.3.1]
b. 16 Jun 1852 d. 29 Jan 1941
12
James W Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.3.2]
b. 31 Dec 1861 d. 24 Jan 1956
11
John Gallman Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.4]
b. 9 Sep 1829 d. 1 Jan 1883
Arminda Tilly Adeline Hays
b. 1824 d. Jul 1862
12
Chloe Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.4.1]
b. 3 Sep 1853 d. 20 Sep 1943 [
=>
]
12
Sarah E Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.4.2]
b. 10 Nov 1855 d. 23 Mar 1939 [
=>
]
12
James P Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.4.3]
b. 29 Dec 1857 [
=>
]
12
Stanley T Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.4.4]
b. 1 Mar 1861 d. 1865
Sarah Oaks
b. 7 Nov 1838 d. 27 Jan 1885
12
William Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.4.5]
b. Abt 1871 d. 23 Sep 1936 [
=>
]
12
Isabel Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.4.6]
b. 5 Mar 1872 d. 7 Jun 1976
12
Amanda Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.4.7]
b. 24 Sep 1874 d. 10 Sep 1956 [
=>
]
12
Arminda E Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.4.8]
b. 29 May 1876 d. 1 Aug 1981 [
=>
]
12
Jesse E Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.4.9]
b. 1 Apr 1878 d. 17 Nov 1938
11
Sarah Ann Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.5]
b. 10 May 1831 d. 28 Nov 1920
William Cicero Denson
b. 20 Oct 1826 d. 10 Jan 1906
12
William Archelaus Perley Denson
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.5.1]
b. 26 Jun 1849 d. 4 Oct 1873
12
John Hilliard Denson
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.5.2]
b. 19 Oct 1850 d. 1 May 1875 [
=>
]
12
James Washington Denson
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.5.3]
b. 7 Apr 1853 d. 4 Feb 1923 [
=>
]
12
Frances Ann Denson
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.5.4]
b. 26 Oct 1855 d. 20 Nov 1855
12
Thomas Cicero Denson
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.5.5]
b. 11 Mar 1857 d. 28 Feb 1935 [
=>
]
12
Clayburne Stanley Denson
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.5.6]
b. 7 Sep 1859 d. 17 Apr 1950 [
=>
]
12
Ezra Dailey Denson
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.5.7]
b. 5 Oct 1861 d. 12 Jan 1944 [
=>
]
12
George Mathers Denson
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.5.8]
b. 10 Dec 1867 d. 15 Sep 1946 [
=>
]
12
Martha Emma Denson
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.5.9]
b. 18 May 1869 d. 29 Nov 1869
12
Rebecca Dora Denson
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.5.10]
b. 14 Dec 1870 d. 8 Mar 1962
12
Sarah Genettie Catherine Denson
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.5.11]
b. 5 Jun 1873
12
Daughter Denson
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.5.12]
b. 27 Sep 1875 d. 27 Sep 1875
11
Susan K Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.6]
b. 25 Oct 1835 d. 22 Oct 1836
11
Thomas Cellars Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.7]
b. 1 Aug 1838 d. 7 Sep 1921
Martha Ellender McKee
b. 15 Jul 1836 d. 21 Oct 1919
12
John Perley Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.7.1]
b. 27 May 1861 d. 11 Mar 1954 [
=>
]
12
William C Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.7.2]
b. 9 Jul 1862 d. 16 Nov 1895 [
=>
]
12
David D Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.7.3]
b. 14 Sep 1864 d. 28 Feb 1886
12
Mary G Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.7.4]
b. 7 Mar 1866
12
George T Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.7.5]
b. Oct 1870 d. Aug 1956 [
=>
]
12
Jesse S Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.7.6]
b. 7 May 1872 d. 27 Feb 1895 [
=>
]
12
Sarah Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.7.7]
b. 1874 d. Dec 1876
12
James M Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.7.8]
b. 11 Jan 1878 d. 31 Dec 1886
12
Benjamin Franklin Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.7.9]
b. Oct 1889 d. 17 Dec 1945 [
=>
]
11
David Daly Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.8]
b. 18 Nov 1840 d. 17 Jan 1923
Sarah E Ritchie
b. 18 Oct 1849 d. 21 Jun 1910
12
Therosie Estelle Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.8.1]
b. Mar 1870 [
=>
]
12
Alfred Pierre Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.8.2]
b. 9 Feb 1872 d. 27 Dec 1958 [
=>
]
12
Son Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.8.3]
b. 5 Mar 1874 d. 8 Mar 1874
12
William Franklin Walter Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.8.4]
b. 5 Mar 1874 d. 23 Feb 1969 [
=>
]
12
Katrina E Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.8.5]
b. 25 Mar 1876 d. 1 Oct 1877
12
Melissa C Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.8.6]
b. 25 Mar 1876 [
=>
]
12
Silas T Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.8.7]
b. 17 Mar 1880 d. 17 May 1956 [
=>
]
12
Nancy Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.8.8]
b. 17 Apr 1880 d. 21 Apr 1942
12
George Elbert Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.8.9]
b. 27 Aug 1884 d. 5 Mar 1964 [
=>
]
12
Thomas Jesse Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.8.10]
b. 16 Jan 1887 d. 28 Apr 1958 [
=>
]
11
William Follett Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.9]
b. 28 Feb 1843 d. 28 Aug 1862
10
Anna Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.3]
b. 1796
10
Mary Ophria Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.4]
b. 1798
10
Joseph Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.5]
b. 12 May 1800 d. 26 Sep 1882
Olive Lindsay
b. 17 Dec 1806 d. 4 Oct 1881
11
Electa Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.5.1]
b. Abt 1827 d. 15 Jun 1854
Chandler Ballard
b. 26 Aug 1826 d. 25 Mar 1861
12
Alice Ballard
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.5.1.1]
b. 8 May 1851
12
Edith Ballard
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.5.1.2]
b. 1853 d. Bef 25 Mar 1861
11
Orville Davencourt Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.5.2]
b. 28 Aug 1829 d. 9 May 1909
Orille Aurilla Day
b. 22 Oct 1829 d. 1917
12
Edwin L Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.5.2.1]
b. 1 May 1851 d. 3 Jun 1908 [
=>
]
12
Addie M Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.5.2.2]
b. 14 Oct 1862
11
Ortan Davencourt Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.5.3]
b. 19 Mar 1833 d. 14 Jan 1908
+
Clarissa Hutchins
b. 1833 d. 1857
Finette Hanahan
b. 1838 d. Mar 1862
12
Clara A Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.5.3.1]
b. 2 May 1861 d. 13 Feb 1931 [
=>
]
Adelia A Pierce
b. Apr 1842 d. 3 Jun 1914
12
Mary Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.5.3.2]
b. 13 Apr 1865 d. 23 May 1929
11
Devillo C Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.5.4]
b. 2 Apr 1835 d. 1 May 1862
11
Annette I Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.5.5]
b. 1838
11
Adelia Minerva Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.5.6]
b. 21 May 1843 d. 4 Apr 1927
Lewis Barbour Mathews
b. 8 Oct 1832 d. 29 Oct 1892
12
Mary Ermina Mathews
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.5.6.1]
b. 9 Dec 1863 d. 26 Dec 1935 [
=>
]
12
Adelia Eliza Mathews
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.5.6.2]
b. 6 Nov 1865 d. 11 Jul 1936 [
=>
]
12
Lindsay Lewis Mathews
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.5.6.3]
b. 14 Feb 1869 d. 23 Jun 1934
12
Etta Mae Mathews
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.5.6.4]
b. 13 Jun 1871 d. 16 Nov 1943 [
=>
]
12
Grace Edna Mathews
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.5.6.5]
b. 15 Nov 1873 d. 4 Jan 1957 [
=>
]
12
Achsah Olive Mathews
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.5.6.6]
b. 6 Aug 1877 d. 27 Mar 1955
12
Max Devillo Mathews
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.5.6.7]
b. 20 Jun 1880 d. 27 Mar 1955 [
=>
]
12
Grover Cleveland Mathews
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.5.6.8]
b. 25 Dec 1883 d. 25 Sep 1968
12
Katherine Adams Mathews
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.5.6.9]
b. 2 May 1887 d. 20 Dec 1977
11
Achsah Amelia Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.5.7]
b. 29 May 1846 d. 26 Jun 1924
Wesley Kinney
b. 15 Dec 1837 d. 17 Mar 1926
12
Maude Kinney
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.5.7.1]
b. 8 Feb 1870 [
=>
]
12
Alvin C Kinney
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.5.7.2]
b. 5 Aug 1873 d. 1900
12
Kenneth Ford Kinney
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.5.7.3]
b. 23 May 1883 d. Dec 1967
10
Chloe Ford
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.6]
b. 1803
Francis L Drake
b. Abt 1800
11
Mayville Deforest Drake
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.6.1]
b. 1839 d. 1910
Julia Ann Woodruff
b. Abt 1850 d. 25 Apr 1914
12
George John Drake
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.6.1.1]
b. May 1870 d. 11 Dec 1946
12
Rose Drake
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.6.1.2]
b. Abt 1872 [
=>
]
12
Irene Drake
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.6.1.3]
b. 22 Jan 1874 d. 13 Dec 1967 [
=>
]
12
William Henry Drake
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.6.1.4]
b. 1875
12
Celestia Drake
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.6.1.5]
b. 1878
12
Bertha Drake
[1.2.1.4.2.1.1.7.2.6.1.6]
b. 19 Mar 1885 [
=>
]
9
Mary Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.3]
b. 10 Oct 1767 d. Bef 1810
9
Abigail Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.4]
b. 18 Feb 1770
John Delong
b. Abt 1768
10
Eunice Delong
[1.2.1.4.2.1.1.7.4.1]
b. 2 Dec 1796 d. 20 Feb 1884
9
Calvin Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.5]
b. 6 Jan 1772 d. 21 Dec 1856
Drusilla Kempton
b. Abt 1787 d. 8 Apr 1856
10
William Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.5.1]
b. 18 Dec 1801
+
Fanny Pierce
b. 7 Jan 1803
10
Benjamin Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.5.2]
b. 22 Oct 1803 d. 11 Dec 1892
Hannah M Warren
b. 16 Jan 1813 d. 18 Jun 1900
11
Edwin Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.5.2.1]
b. Abt 1829
11
N Ellen Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.5.2.2]
b. Abt 1830
11
Hannah Ellen Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.5.2.3]
b. 3 Feb 1830
10
Ephraim Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.5.3]
b. 24 Dec 1805 d. 1 May 1864
Diana Higgins
b. 18 Mar 1806 d. 30 May 1886
11
Ephraim E Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.5.3.1]
b. 1835 d. 23 Nov 1911
Violette Messinger
b. 24 Mar 1842 d. 3 Mar 1916
12
Emily Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.5.3.1.1]
b. 26 Mar 1863 [
=>
]
12
Ellen Follette
[1.2.1.4.2.1.1.7.5.3.1.2]
b. 27 Nov 1864 d. 30 Oct 1871
12
Marvin J Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.5.3.1.3]
b. 19 Jun 1867 d. 14 Dec 1943
12
Irving Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.5.3.1.4]
b. 14 Apr 1869
11
Edward Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.5.3.2]
b. Abt 1836
11
Willard Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.5.3.3]
b. 1838 d. 1 Dec 1917
11
Oliver Stowell Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.5.3.4]
b. Abt 1849
11
Emily Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.5.3.5]
b. 26 Mar 1863
Will H Wood
b. Oct 1859
12
Gaila B Wood
[1.2.1.4.2.1.1.7.5.3.5.1]
b. Aug 1884 d. 23 Jun 1908
12
Fredrick K Wood
[1.2.1.4.2.1.1.7.5.3.5.2]
b. Feb 1887
12
James B Wood
[1.2.1.4.2.1.1.7.5.3.5.3]
b. May 1891
12
Beth E Wood
[1.2.1.4.2.1.1.7.5.3.5.4]
b. May 1893
11
William Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.5.3.6]
b. 16 Aug 1841
+
Anna Augusta Ives
b. 12 Sep 1849 d. 7 Nov 1911
10
Calvin Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.5.4]
b. 1807
Samantha
b. 1823
11
Ellen Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.5.4.1]
b. Abt 1850
11
Eugene W Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.5.4.2]
b. Oct 1851 d. 6 Apr 1906
Eliza Catherine Howard
b. 1856 d. 25 Mar 1894
12
Cora Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.5.4.2.1]
b. Abt 1879
12
Symantha Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.5.4.2.2]
b. 1881
12
Agnes Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.5.4.2.3]
b. 1883
12
Adelbert Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.5.4.2.4]
b. May 1887 d. 13 Nov 1956
12
Catherine Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.5.4.2.5]
b. 1889
11
Edwin B Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.5.4.3]
b. Jan 1855
Anna W Fry
b. Jun 1859
12
Frederick M Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.5.4.3.1]
b. 24 Jul 1879
10
Anna Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.5.5]
b. 1809 d. 24 Aug 1832
10
Daughter Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.5.6]
b. 1810
10
Daughter Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.5.7]
b. 1813
10
Hiram Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.5.8]
b. 1 Nov 1816 d. 20 Jan 1892
Emily Ames
b. 10 Jul 1818 d. 14 Oct 1885
11
Maria Louisa Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.5.8.1]
b. 8 Feb 1847 d. 17 Nov 1866
11
Anna A Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.5.8.2]
b. 18 May 1849 d. 15 Apr 1936
Caleb Cranson Jennings
b. 20 Jul 1845 d. 28 Jan 1927
12
Myrta Pauline Jennings
[1.2.1.4.2.1.1.7.5.8.2.1]
b. 17 Aug 1878 d. 29 Aug 1960 [
=>
]
12
Emogene Beatrice Jennings
[1.2.1.4.2.1.1.7.5.8.2.2]
b. 20 Jul 1880 d. 23 Apr 1922 [
=>
]
12
Edna Jennings
[1.2.1.4.2.1.1.7.5.8.2.3]
b. 9 Jul 1882 d. 4 Jul 1972 [
=>
]
11
Edgar Ames Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.5.8.3]
b. 19 Dec 1857 d. 24 Jul 1924
10
Louisa Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.5.9]
b. 1819
10
Calvin Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.5.10]
b. 1822
10
Mary Jane Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.5.11]
b. 1825
Isaac Maldron
b. Abt 1821
11
Saprillet Maldron
[1.2.1.4.2.1.1.7.5.11.1]
b. Abt 1851
11
Falconer Maldron
[1.2.1.4.2.1.1.7.5.11.2]
b. Abt 1854
11
Purley Maldron
[1.2.1.4.2.1.1.7.5.11.3]
b. Abt 1856
11
Hanley Maldron
[1.2.1.4.2.1.1.7.5.11.4]
b. Abt 1858
10
Fanny Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.5.12]
b. 1831 d. 11 Mar 1832
9
Elijah Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6]
b. 29 Mar 1775 d. Jul 1816
Sabra Hill
b. 28 Apr 1779 d. 24 Apr 1842
10
John Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.1]
b. Abt 1799
+
Paulina
b. Abt 1813
10
Sarah "Sally" Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.2]
b. Abt 1803
Henry Robinson
b. 1800 d. Aug 1874
11
Thomas W Robinson
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.2.1]
b. 1830
11
George H Robinson
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.2.2]
b. 1834
11
James M Robinson
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.2.3]
b. Abt 1836
Mary A Ray
b. May 1838
12
William Robinson
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.2.3.1]
b. Abt 1859
12
James R Robinson
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.2.3.2]
b. Abt 1862
12
Charles Robinson
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.2.3.3]
b. Abt 1864
12
Martha "Mattie" Robinson
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.2.3.4]
b. 12 Apr 1867
12
Ida Robinson
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.2.3.5]
b. Abt 1870
12
Eugene Robinson
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.2.3.6]
b. Abt 1871
11
Mary Elizabeth Robinson
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.2.4]
b. 1843 d. 1913
John J Plunkett
b. 1842 d. 1911
12
Jonathan Commodore Plunkett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.2.4.1]
b. 1 May 1861 d. 31 Jul 1925 [
=>
]
12
Mary Alice Plunkett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.2.4.2]
b. 1866 d. 1936
12
Julia Ann Plunkett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.2.4.3]
b. 1868 d. 1938 [
=>
]
12
Soulden Plunkett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.2.4.4]
b. 10 Oct 1871 d. 6 Sep 1941
12
Ida Plunkett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.2.4.5]
b. 1874 d. 1884
12
Nina Plunkett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.2.4.6]
b. 1878 d. 1948
12
Leslie Plunkett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.2.4.7]
b. 1880 d. 1950
10
Samuel Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3]
b. 26 Dec 1803 d. 1885
Marinda Rockwell
b. 1804 d. 5 Mar 1867
11
Erastus Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.1]
b. 18 Mar 1827 d. 22 Mar 1886
Lurancy Mann
b. May 1811 d. 7 Jul 1891
12
Daughter Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.1.1]
b. 1830
12
Louisa Jane Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.1.2]
b. 19 Jun 1832
12
Ann Elizabeth Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.1.3]
b. 5 Nov 1834
12
William Mann Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.1.4]
b. 19 Sep 1836 [
=>
]
12
Mary A Follette
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.1.5]
b. 1838 d. 1844
12
Melvina C Follette
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.1.6]
b. 1840 d. 1841
12
Melissa E Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.1.7]
b. 1843 d. 1862
12
John Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.1.8]
b. 1845
12
Hamilton B Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.1.9]
b. 11 Dec 1846 d. 20 Mar 1893 [
=>
]
12
Orvis Marion Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.1.10]
b. 14 Dec 1847 d. 26 Jun 1938 [
=>
]
12
John Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.1.11]
b. 1850
12
Hector Tupper Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.1.12]
b. 10 Feb 1855 d. 31 Aug 1915 [
=>
]
12
Charles E Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.1.13]
b. Aug 1856 [
=>
]
11
David M Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.2]
b. 1828 d. 29 Nov 1889
Almira Goodrich
b. 23 Jan 1833 d. 18 Jan 1904
12
Edwin Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.2.1]
b. 3 Aug 1850 d. 27 Sep 1916 [
=>
]
12
Ervin A Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.2.2]
b. 1851
12
Haller H Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.2.3]
b. 1852 d. 20 Nov 1924
12
Ernest A Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.2.4]
b. 1853 d. 21 Apr 1923
12
Alexander Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.2.5]
b. 1855
12
Willis Andrew Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.2.6]
b. 22 Feb 1855 d. 13 Jul 1933
12
Charles B Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.2.7]
b. Apr 1857 d. 10 Oct 1918
12
Hallen Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.2.8]
b. 1859
12
William Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.2.9]
b. 1860
12
Ralph Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.2.10]
b. 17 Apr 1861 d. 17 Sep 1930 [
=>
]
Janet Morey
b. 1842
12
Max Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.2.11]
b. 1863
12
Anna M Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.2.12]
b. 1865
12
Malcolm Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.2.13]
b. 1866
11
Marchel Abraham Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.3]
b. 2 May 1830 d. 30 Jul 1907
Susan A Goodrich
b. 18 Feb 1828 d. 27 Aug 1918
12
William Spencer Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.3.1]
b. 16 Oct 1855 d. Aft 1927 [
=>
]
12
Emma Amelia Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.3.2]
b. 14 Aug 1857 d. 15 Nov 1921 [
=>
]
12
Frances Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.3.3]
b. 4 Jan 1860 d. 22 Oct 1933 [
=>
]
12
Ellen Follet
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.3.4]
b. 20 Dec 1861 [
=>
]
12
George A Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.3.5]
b. 1862 d. 30 Jan 1939
12
Harriett Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.3.6]
b. 16 Sep 1863 d. 26 Mar 1864
12
Henry P Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.3.7]
b. 11 Dec 1865 d. Aft 1928
12
Ellen M Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.3.8]
b. Abt 1869
12
Frankie Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.3.9]
b. Abt 1871
12
William S Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.3.10]
b. Abt 1873
11
John D Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.4]
b. 1832 d. 1900
Carolina Genung
b. 1835
12
Daniel Grant Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.4.1]
b. 4 Mar 1865 d. 20 Feb 1957 [
=>
]
12
George H Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.4.2]
b. 28 Feb 1867 d. 10 Jan 1950
12
Elizabeth Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.4.3]
b. 1869
12
John Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.4.4]
b. 1871
12
Jay Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.4.5]
b. 1874
12
Della Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.4.6]
b. 1877
12
Merrit Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.4.7]
b. 1880 d. 1930
12
Anna M Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.4.8]
b. Apr 1883 d. 16 Jan 1955
12
Mary A Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.4.9]
b. May 1891 d. 16 Jan 1955
11
Harlow Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.5]
b. 15 Aug 1834 d. 2 Jul 1911
Rachael Goodrich
b. 10 Jun 1844 d. 30 May 1906
12
Jessie Adell Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.5.1]
b. 25 Jul 1862 d. 17 Nov 1940 [
=>
]
12
Adelbert Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.5.2]
b. 25 Feb 1866 d. 2 Apr 1867
12
Dudley James Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.5.3]
b. 8 Sep 1872 d. 21 Jun 1917 [
=>
]
12
Walter Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.5.4]
b. 7 May 1874 d. 17 Oct 1950 [
=>
]
12
Lillian Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.5.5]
b. 6 Jan 1876 d. 30 Apr 1896
12
Ora Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.5.6]
b. 21 Sep 1878 d. 1960
12
Lena Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.5.7]
b. 2 May 1886 d. 29 Nov 1953
11
Orville Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.6]
b. Abt 1834
11
Mary Jane Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.7]
b. 1839 d. 21 Apr 1862
11
Samuel Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.8]
b. 12 Apr 1840 d. 7 Apr 1917
Martha Pike
b. 13 Oct 1843
12
Mary Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.8.1]
b. 8 Jun 1862 d. 1 Apr 1864
12
Samuel K Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.8.2]
b. 7 Aug 1864 d. 12 May 1878
12
Nelson W Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.8.3]
b. 1 Nov 1866 d. 18 Nov 1936
12
Hurbert Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.8.4]
b. 27 Feb 1867 d. 23 Apr 1941
12
Clark E Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.8.5]
b. 23 Aug 1870 d. 30 Jan 1901
12
Floyd Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.8.6]
b. 19 Nov 1875 d. 1948
12
Flora Martha Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.8.7]
b. 29 Dec 1883 d. 1 Jun 1974
11
Mary Ann Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.9]
b. Abt 1841
11
Orren Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.10]
b. Feb 1842 d. 26 Jul 1907
11
George W Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.11]
b. 29 Mar 1845 d. 9 Jul 1926
Mary Elizabeth Guile
b. 22 Sep 1840 d. 21 Mar 1883
12
Julia Merinda Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.11.1]
b. 3 Sep 1867 d. 19 Dec 1935
12
George Clinton Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.11.2]
b. 28 Dec 1871 d. 10 Aug 1938
12
Whitman Abram Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.11.3]
b. Jan 1873 d. 25 Mar 1938 [
=>
]
12
Frank Dewitt Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.11.4]
b. 8 Jun 1883 d. 20 Sep 1957
11
Willard Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.12]
b. 27 Jul 1847 d. 14 Sep 1916
Helen Holdredge
b. 29 Aug 1847 d. 12 May 1921
12
Frederick D Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.12.1]
b. 10 Dec 1870 d. 29 Oct 1938
12
Addie W Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.12.2]
b. 5 Feb 1878 d. 9 Apr 1941
10
Orpha Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.4]
b. Abt 1805
+
John Harrington
b. 9 Jun 1803
10
Daniel Edward Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.5]
b. 11 Nov 1807 d. 27 Nov 1901
Catherine Jane Longyear
b. 27 Apr 1814 d. 15 Jun 1886
11
Emmerson Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.5.1]
b. Sep 1835
Mary A King
b. 1 Jun 1839 d. 12 Aug 1866
12
Frances Margaret Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.5.1.1]
b. Nov 1863 d. 1910 [
=>
]
12
James E Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.5.1.2]
b. 14 May 1866 d. 3 Aug 1866
Mariah Bristow
b. 1848 d. 28 Mar 1891
12
Mary Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.5.1.3]
b. 20 Feb 1870 d. 19 Jul 1880
12
Rosella Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.5.1.4]
b. 15 Feb 1879 d. 24 Jul 1879
12
Eva Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.5.1.5]
b. 16 Aug 1880
12
William Adam Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.5.1.6]
b. 18 Oct 1882 d. 7 Feb 1901
12
Lulu Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.5.1.7]
b. 18 Oct 1883 d. 5 Jul 1884
12
Richard Alphonso Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.5.1.8]
b. 21 Dec 1889 d. Mar 1991
11
Mary Jane Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.5.2]
b. 12 Feb 1837 d. 15 Jan 1915
Samuel Hepburn Maxwell
b. 20 Jul 1826 d. 24 Apr 1899
12
Josephine Maxwell
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.5.2.1]
b. Abt 1854
12
Harry Stoddard Maxwell
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.5.2.2]
b. Abt 1857 d. 15 Nov 1930 [
=>
]
12
Rolla Maxwell
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.5.2.3]
b. 2 Nov 1859 d. 27 Mar 1913 [
=>
]
12
Charles Calvin Maxwell
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.5.2.4]
b. 1862 d. 1931
12
William Hepburn Maxwell
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.5.2.5]
b. 1 Feb 1868 d. 14 Jul 1941 [
=>
]
12
Kate Maxwell
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.5.2.6]
b. Abt 1864
12
Fred Maxwell
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.5.2.7]
b. Abt 1870
12
Richard Maxwell
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.5.2.8]
b. Abt 1872
11
Daughter Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.5.3]
b. 1839
11
Calvin Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.5.4]
b. Nov 1843
Eliza Spray
b. 1847
12
Charles Calvin Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.5.4.1]
b. Dec 1867 [
=>
]
12
Albert Houston Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.5.4.2]
b. 1870 [
=>
]
12
Ida M Follet
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.5.4.3]
b. 1873 d. 1873
12
Marquis de Lafeyette Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.5.4.4]
b. Aug 1875 [
=>
]
12
James Archibald Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.5.4.5]
b. 29 Aug 1876 d. 24 Jun 1955
12
Coleman Moss Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.5.4.6]
b. 1 Sep 1878 d. 22 Mar 1943
12
Bertha C Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.5.4.7]
b. 13 Oct 1884
11
Sarah Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.5.5]
b. 1844
11
James Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.5.6]
b. 1845
11
Daniel Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.5.7]
b. 1846
11
Charles Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.5.8]
b. 1849
11
Frances Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.5.9]
b. 1851
11
Lurancy Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.5.10]
b. Abt 1852
George Mason Duncan
b. 1853
12
Daniel Henry Duncan
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.5.10.1]
b. 4 Oct 1877
10
Eunice Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.6]
b. Abt 1809
+
John Harrington
10
Ann Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.7]
b. Abt 1811
+
John Orr
10
Elsie Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.8]
b. 1811
10
Joseph Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.9]
b. 17 Jun 1814 d. 1897
Cynthia Stiles
b. 3 Jan 1823 d. 2 Jun 1900
11
John D Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.9.1]
b. 30 Sep 1845 d. 5 Oct 1846
11
Sabra Ann Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.9.2]
b. 15 Sep 1847 d. 18 Sep 1908
Jacob Brewer
b. 21 Jun 1833 d. 24 May 1909
12
Jacob Albert Brewer
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.9.2.1]
b. 15 Jun 1865 d. 1 Jul 1925
12
Joseph Lewis Brewer
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.9.2.2]
b. 3 Aug 1867 d. 20 Jan 1942 [
=>
]
12
Charles Frederick Brewer
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.9.2.3]
b. 8 Sep 1869 d. 26 Oct 1887
12
Harriett Louisa Brewer
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.9.2.4]
b. 13 Mar 1872 d. 23 Mar 1964 [
=>
]
12
Adam Rufus Brewer
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.9.2.5]
b. 21 Feb 1874 d. 9 Feb 1957 [
=>
]
12
George Franklin Brewer
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.9.2.6]
b. 21 May 1876 d. 25 Apr 1877
12
John Hyrum Brewer
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.9.2.7]
b. 10 Feb 1878 d. 8 Feb 1950 [
=>
]
12
Emma Ann Brewer
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.9.2.8]
b. 3 Apr 1880 d. 27 Oct 1887
12
William Henry Brewer
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.9.2.9]
b. 24 Feb 1882 d. 20 Aug 1882
12
Cynthia Jane Brewer
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.9.2.10]
b. 8 Aug 1883 d. 23 Oct 1887
12
Alice May Brewer
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.9.2.11]
b. 11 Mar 1886 d. 6 Apr 1934
11
Cornelia Jane Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.9.3]
b. 25 Apr 1849 d. 12 Jul 1901
James T Wilson
b. 19 Sep 1835 d. 4 May 1912
12
Cynthia Jane Wilson
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.9.3.1]
b. 20 Jul 1869 d. 25 Mar 1958 [
=>
]
12
Mary Louise "Mame" Wilson
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.9.3.2]
b. 1871 d. 1944
12
Loretta Ann Wilson
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.9.3.3]
b. 6 Jan 1873 d. Sep 1954
12
Fannie Matilda Wilson
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.9.3.4]
b. Sep 1876 d. 1956 [
=>
]
12
Amelia Antoinette Wilson
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.9.3.5]
b. 19 Dec 1879 d. 7 Jan 1899
12
Joseph Franklin Wilson
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.9.3.6]
b. 1 Oct 1884 d. 3 Dec 1958
12
James Roy Wilson
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.9.3.7]
b. 30 May 1888 d. 10 Mar 1951 [
=>
]
11
Joseph Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.9.4]
b. 29 Aug 1850 d. 4 Oct 1909
11
Sarah Louisa Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.9.5]
b. 27 Oct 1851 d. 29 Mar 1863
11
Gerome M Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.9.6]
b. 24 Jul 1855 d. 18 May 1858
11
Henry Francis Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.9.7]
b. 12 May 1859 d. Nov 1927
11
Mary Elizabeth Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.6.9.8]
b. 29 Aug 1861 d. 27 Dec 1862
9
Samuel Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.7]
b. 2 Apr 1776
Rebecca
b. Abt 1778
10
Permelia Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.7.1]
b. Abt 1817
9
William Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.8]
b. 3 Mar 1778 d. 1853
Sybil Blackman
b. 1780 d. Bef 1850
10
Betsy Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.8.1]
b. 1808
10
Ann Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.8.2]
b. 1810
10
John Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.8.3]
b. 1813
Hannah
b. Abt 1815
11
Martin Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.8.3.1]
b. Bef 1850
10
William Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.8.4]
b. 1820
Hannah
b. Abt 1825
11
Frances E Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.8.4.1]
b. Abt 1857 d. 20 Oct 1899
10
Hannah Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.8.5]
b. 21 Feb 1824 d. 21 Oct 1898
10
Samuel B Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.8.6]
b. 6 Nov 1827 d. 13 Feb 1920
Almeda White
11
Charles S Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.8.6.1]
b. 4 Mar 1856 d. 20 Jan 1863
11
Edward W Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.8.6.2]
b. 23 Sep 1865 d. 26 Mar 1928
+
Esther Osborn
b. 1 Apr 1842 d. 21 Oct 1895
10
Henry Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.8.7]
b. 15 Oct 1829 d. 31 May 1905
9
Eunice Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.9]
b. 28 Mar 1779
Joseph Baker
b. Abt 1777
10
Joseph Baker, Jr
[1.2.1.4.2.1.1.7.9.1]
b. Abt 1799
10
John Baker
[1.2.1.4.2.1.1.7.9.2]
b. Abt 1801
10
Erastus Baker
[1.2.1.4.2.1.1.7.9.3]
b. Abt 1803
+
Loraney Mann
10
Norma Baker
[1.2.1.4.2.1.1.7.9.4]
b. Abt 1805
10
Maria Baker
[1.2.1.4.2.1.1.7.9.5]
b. 1809
John B Van Dyke
b. 9 Oct 1808 d. 30 Jul 1883
11
Richard W Van Dyke
[1.2.1.4.2.1.1.7.9.5.1]
b. 28 Feb 1836 d. 28 Mar 1864
+
Eliza Maria Preston
b. 23 Jun 1834 d. 14 Dec 1882
11
John Van Dyke
[1.2.1.4.2.1.1.7.9.5.2]
b. 6 Jan 1839
+
Nancy Jane "Jennie" Older
b. 20 Aug 1842 d. 25 Jul 1916
9
John Follett
[1.2.1.4.2.1.1.7.10]
b. 22 Aug 1783
+
Lydia Reed
b. 1785
8
Calvin Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.8]
b. 17 Aug 1745 d. 10 Nov 1762
8
Deborah Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.9]
b. 6 Aug 1747
8
Daniel Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10]
b. 7 Sep 1749 d. 1798
Deborah Hildreth
b. 5 May 1755 d. Abt 1789
9
Samuel Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.1]
b. 1777 d. Aft 1800
9
Daniel Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2]
b. 27 Aug 1779 d. 27 Sep 1839
Mary Tiffany
b. 17 Jun 1777 d. 12 Sep 1845
10
Cynthia Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.1]
b. 15 Jan 1805 d. 1889
Ezra Gray
b. 1793 d. 1870
11
Hiram T Gray
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.1.1]
b. 25 Aug 1832 d. 30 Jun 1875
+
Caroline R Lane
b. 1839 d. 1902
11
Daniel William Gray
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.1.2]
b. 19 May 1834 d. 9 Dec 1890
Eliza Jane Ostrander
b. Abt 1840 d. 29 Oct 1861
12
William Delvin Grey
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.1.2.1]
b. 27 Feb 1859 d. 11 Aug 1949
12
Frank Gray
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.1.2.2]
b. Abt 1861
Sarah Ann Smith
b. 19 Dec 1851 d. 15 Jan 1941
12
Jennie Gray
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.1.2.3]
b. 3 May 1870 d. 5 Oct 1941
12
Nellie F Gray
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.1.2.4]
b. 2 Jul 1871 d. Aug 1883
12
Frank N Gray
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.1.2.5]
b. 3 Nov 1873
12
Mary Ellen Gray
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.1.2.6]
b. 27 Aug 1877 d. 23 Feb 1953
12
Carrie M Gray
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.1.2.7]
b. 8 Dec 1881 d. 12 Sep 1949
11
Daughter Gray
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.1.3]
b. 1834
11
Emily Jane Gray
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.1.4]
b. 14 Nov 1837 d. 13 Feb 1908
11
Betsey T Gray
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.1.5]
b. 1840
11
Mary M Gray
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.1.6]
b. 1844
11
George W Gray
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.1.7]
b. 1846 d. 4 Aug 1918
Sidney
b. Jan 1846
12
Ramond G Gray
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.1.7.1]
b. Apr 1869
12
Minnie M Gray
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.1.7.2]
b. May 1872 [
=>
]
12
Floyd Gray
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.1.7.3]
b. Sep 1874
12
Daisey M Gray
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.1.7.4]
b. Jun 1881
10
Samuel Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.2]
b. 21 Dec 1808 d. 9 Jan 1887
Phoebe Kingsbury
b. 14 Dec 1812 d. 24 Apr 1851
11
Sabrina Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.2.1]
b. 30 Mar 1832 d. 1920
+
Scudder Todd
b. 1831 d. 1901
11
George T Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.2.2]
b. 4 Dec 1833 d. 28 Aug 1868
11
Polly Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.2.3]
b. 4 Jun 1835 d. 24 Mar 1855
11
Daniel Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.2.4]
b. 21 Jun 1837
11
Margaret Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.2.5]
b. 18 Jun 1839 d. 8 Oct 1840
11
Mason Kingsbury Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.2.6]
b. 17 Feb 1842 d. 27 Mar 1919
Olive Amanda Kingsbury
b. 10 Dec 1844 d. 1924
12
Nelson E Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.2.6.1]
b. 1867 d. 1943
12
Ina Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.2.6.2]
b. Sep 1869
12
George W Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.2.6.3]
b. Jan 1872
12
Pearl O Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.2.6.4]
b. Jun 1884
11
Samuel Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.2.7]
b. 4 Mar 1844 d. May 1924
11
Hassett Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.2.8]
b. 20 Feb 1846 d. 3 Jan 1852
11
Almira Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.2.9]
b. 21 Apr 1848 d. 22 Sep 1911
+
Franklin F King
b. 1845 d. 1898
11
Cynthia Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.2.10]
b. 10 Nov 1850 d. 17 Apr 1851
10
Almira Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.3]
b. 13 Jun 1810 d. 4 Feb 1889
George Tiffany
b. 4 May 1808 d. 21 Jun 1885
11
Cynthia Jane Tiffany
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.1]
b. 2 Feb 1830 d. 6 Oct 1845
11
Zenos Tiffany
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.2]
b. 21 Jul 1831 d. Dec 1843
11
Ira Patchen Tiffany
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.3]
b. 14 Feb 1835 d. 21 Mar 1905
Mary Ann Davis
b. 4 Oct 1843 d. 21 Jul 1885
12
Ira Davies Tiffany
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.3.1]
b. 24 Jul 1863 d. 27 Oct 1902
12
Zenos William Tiffany
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.3.2]
b. 21 Aug 1865 d. 14 Feb 1938
12
Sylvia Ann Tiffany
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.3.3]
b. 14 Nov 1867 d. 23 Dec 1936
12
Cynthia Jane Tiffany
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.3.4]
b. 27 Feb 1870 d. Bef 1877
12
Mary Elizabeth Tiffany
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.3.5]
b. 17 May 1871 d. 5 Nov 1887
12
Almira Tiffany
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.3.6]
b. 29 Dec 1873 d. 21 Sep 1887
12
Franklin Brayn Tiffany
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.3.7]
b. 29 Feb 1876 d. 4 Oct 1877
12
Eliza Tiffany
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.3.8]
b. 30 Jan 1878 d. 2 Jun 1957
12
George Hyrum Tiffany
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.3.9]
b. 17 Apr 1880 d. 18 Mar 1939
12
Albert Henry Tiffany
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.3.10]
b. 5 Nov 1882 d. 2 Dec 1956
12
Ray Tiffany
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.3.11]
b. 21 Jul 1884 d. 16 Oct 1885
+
Sarah Ann Jolley
b. 18 Dec 1837 d. 9 Jan 1919
11
Loyal Peck Tiffany
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.4]
b. 27 Jul 1837 d. 15 Feb 1903
+
Martha Holden
b. 28 Jan 1825 d. 3 May 1886
11
Mary Tiffany
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.5]
b. 18 Dec 1844 d. 14 Dec 1845
11
Almira Rebecca Tiffany
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.6]
b. 18 Aug 1847 d. 23 Nov 1914
Giles Bliss Holden
b. 8 May 1842 d. 20 May 1897
12
Almira Rebecca Holden
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.6.1]
b. 8 Aug 1865 d. 25 Aug 1865
12
Ruia Angeline Holden
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.6.2]
b. 21 Oct 1866 d. 4 Mar 1948
12
Giles Robert Holden
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.6.3]
b. 8 Dec 1868 d. Mar 1889
12
Cynthia Holden
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.6.4]
b. 10 Mar 1870 d. 10 Mar 1870
12
George Tiffany Holden
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.6.5]
b. 9 May 1872 d. 13 Apr 1934
12
Nellie May Holden
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.6.6]
b. 30 Dec 1875 d. 6 Nov 1935
12
Burrell Henry Holden
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.6.7]
b. 29 Jun 1877 d. 11 Mar 1881
12
Leroy Edwin Holden
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.6.8]
b. 21 Sep 1879 d. 12 Feb 1881
12
Ivy LeNore Holden
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.6.9]
b. 24 May 1882 d. 18 Aug 1958
12
Merle Dee Holden
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.6.10]
b. 10 Jul 1885 d. 12 Sep 1938
12
Verna Holden
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.6.11]
b. 18 Dec 1887 d. 18 Dec 1887
12
Vera Holden
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.6.12]
b. 18 Dec 1887 d. 12 Feb 1967 [
=>
]
11
George Mason Tiffany
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.7]
b. 31 Jan 1850 d. 14 Mar 1909
Sarah Jane York
b. 18 Feb 1857 d. 27 Dec 1940
12
Mary Ellen Tiffany
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.7.1]
b. 22 Aug 1874 d. 18 Jun 1958
12
Sarah Jane Tiffany
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.7.2]
b. 16 Apr 1876 d. 23 Apr 1883
12
George Mason Tiffany
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.7.3]
b. 17 Nov 1877 d. 21 Apr 1883
12
Asa York Tiffany
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.7.4]
b. 24 Feb 1881 d. 3 Feb 1947
12
Lea Tiffany
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.7.5]
b. 7 May 1883 d. 7 Jan 1961
12
Ira George Tiffany
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.7.6]
b. 7 May 1883 d. 7 Jan 1961
12
Nelson Tiffany
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.7.7]
b. 4 Aug 1885 d. 27 Mar 1943
12
Almira Tiffany
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.7.8]
b. 16 Sep 1888 d. 26 Jul 1966
12
Ruia Tiffany
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.7.9]
b. 27 Nov 1890 d. 15 May 1965
12
Lenore Henrietta Tiffany
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.7.10]
b. 9 Aug 1893 d. 11 Sep 1967
11
Nelson Whipple Tiffany
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.8]
b. 6 Aug 1852 d. 20 Jan 1927
Nancy Medora Beesley
b. 8 Sep 1862 d. 15 May 1924
12
Nelson Whipple Tiffany
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.8.1]
b. 11 Sep 1880 d. 20 Nov 1904
12
Florence Tiffany
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.8.2]
b. 27 Apr 1882 d. 22 May 1964
12
Alathea Tiffany
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.8.3]
b. 28 Aug 1884 d. 3 Jan 1897
12
Ida May Tiffany
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.8.4]
b. 15 Nov 1888 d. 9 May 1968
12
George Milton Tiffany
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.8.5]
b. 8 May 1892 d. 25 May 1963
12
Martha Elva Tiffany
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.8.6]
b. 1 Aug 1898 d. 25 Nov 1989
12
Viola Tiffany
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.8.7]
b. 5 Jul 1903 d. 19 Jun 1969
10
Phoebe Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.4]
b. 13 Aug 1813 d. 18 Nov 1846
Benjamin Bengraw Shaw
b. 1808
11
Clymenia Azuba Shaw
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.4.1]
b. 2 Feb 1834 d. 10 Aug 1920
David Evans
b. 27 Oct 1804 d. 23 Jun 1883
12
Phebe Jane Evans
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.4.1.1]
b. 1 Dec 1855 d. 18 Dec 1855
12
James Evans
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.4.1.2]
b. 16 Aug 1857 d. 15 Apr 1940 [
=>
]
12
Edwin Thomas Evans
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.4.1.3]
b. 2 Feb 1860 d. 4 Mar 1946 [
=>
]
Benjamin Gibson
b. 9 May 1805 d. 26 Nov 1897
11
Hannah Gibson
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.4.2]
b. 24 Apr 1836 d. 31 Oct 1846
11
Isabella Amy Gibson
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.4.3]
b. 20 Mar 1838 d. 11 Feb 1898
William Coleman
b. 9 Dec 1836 d. 12 Feb 1910
12
William Coleman, Jr
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.4.3.1]
b. 3 Oct 1858 d. 19 Aug 1936 [
=>
]
12
Phebe Jane Coleman
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.4.3.2]
b. 20 May 1860 d. 11 Jun 1936 [
=>
]
12
Benjamin Leo Coleman
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.4.3.3]
b. 2 Sep 1862 d. 23 Jan 1937 [
=>
]
12
Amy Jane Coleman
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.4.3.4]
b. 13 May 1865 d. 19 Oct 1865
12
Mary Elizabeth Coleman
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.4.3.5]
b. 12 Apr 1866 d. 12 Dec 1869
12
John Coleman
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.4.3.6]
b. 6 Nov 1866 d. 24 Jul 1937 [
=>
]
12
Franklin Coleman
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.4.3.7]
b. 18 Mar 1868 d. 1 Jul 1917 [
=>
]
12
Hyrum Coleman
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.4.3.8]
b. 19 Aug 1868 d. 8 Oct 1947 [
=>
]
12
Prime Henry Coleman
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.4.3.9]
b. 24 Apr 1871 d. 30 Mar 1948
12
Sarah Francetta Coleman
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.4.3.10]
b. 20 Jun 1875 d. 9 May 1931 [
=>
]
12
Esther Coleman
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.4.3.11]
b. 8 Dec 1880 d. 1 Mar 1908 [
=>
]
11
Mary Jane Gibson
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.4.4]
b. 5 Feb 1840 d. 12 Jun 1912
Orson Kelsey
b. 1 Oct 1840 d. 7 May 1922
12
Mary Ellen Kelsey
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.4.4.1]
b. 22 Jan 1860 d. 28 Oct 1889 [
=>
]
12
Orson Kelsey, Jr
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.4.4.2]
b. 27 Aug 1861 d. 23 Mar 1904 [
=>
]
12
Benjamin Franklin Kelsey
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.4.4.3]
b. 6 Jun 1865 d. 28 Sep 1937 [
=>
]
12
Orin Kelsey
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.4.4.4]
b. 27 Sep 1866 d. 28 Sep 1866
12
George Albert Kelsey
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.4.4.5]
b. 6 Nov 1868 d. 10 Sep 1946
12
Theodore Kelsey
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.4.4.6]
b. 20 May 1871 d. 2 May 1963 [
=>
]
12
Abigail Kelsey
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.4.4.7]
b. 17 Feb 1873 d. 10 Dec 1956 [
=>
]
12
Easton Lemoine Kelsey
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.4.4.8]
b. 18 Oct 1875 d. 23 Jul 1963 [
=>
]
12
Amos C Kelsey
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.4.4.9]
b. 26 Jul 1876 d. 5 Sep 1956 [
=>
]
12
Rupert Lee Kelsey
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.4.4.10]
b. 8 Dec 1878 d. 12 Aug 1961 [
=>
]
12
Elmira Kelsey
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.4.4.11]
b. 10 Nov 1880 d. 19 Feb 1958 [
=>
]
12
Phoebe Jane Kelsey
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.4.4.12]
b. 23 Aug 1882 d. 16 Jul 1964 [
=>
]
11
Susan Jane Gibson
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.4.5]
b. 11 Oct 1842 d. 25 May 1929
John Franklin Sanders
b. 5 Mar 1830 d. 18 Mar 1896
12
Phebe Jane Sanders
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.4.5.1]
b. 23 Jan 1866 d. 9 May 1950 [
=>
]
12
Amanda Ann Sanders
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.4.5.2]
b. 14 Nov 1867 d. Aug 1868
12
Amy Elmira Sanders
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.4.5.3]
b. 8 Aug 1869 d. 25 Sep 1925
12
William Franklin Sanders
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.4.5.4]
b. 6 Jan 1872 d. 15 Nov 1906
12
Ellen Clymena Sanders
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.4.5.5]
b. 14 Jan 1874 d. 8 Oct 1953 [
=>
]
12
Joseph Myron Sanders
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.4.5.6]
b. 12 Mar 1876 d. 8 Jun 1944 [
=>
]
11
Jemima Gibson
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.4.6]
b. 1847
10
Carum Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.5]
b. 12 Aug 1815 d. 1843
10
Gerua Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.6]
b. 12 Aug 1815 d. 18 Sep 1848
10
Nelson Wheeler Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7]
b. 11 Jul 1818 d. 5 Jul 1887
Susan Jane Bailey
b. 9 Mar 1828 d. 5 Jun 1856
11
Son Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.1]
b. 15 Oct 1844 d. 15 Oct 1844
11
Miranda Jane Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.2]
b. 14 Mar 1847 d. 29 Dec 1907
+
John Williams
b. 8 Oct 1840 d. 21 May 1899
David R Barton
b. 1835
12
David Albert Barton
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.2.1]
b. 22 Jan 1865 d. 3 Sep 1930
12
Elizabeth M Barton
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.2.2]
b. Apr 1868 d. 15 Oct 1917 [
=>
]
12
Mary Ellen Barton
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.2.3]
b. 26 Jul 1870 d. 2 Feb 1926 [
=>
]
Henry Codd
b. 21 Aug 1836 d. 20 Jan 1911
12
Eliza Isabella Code
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.2.4]
b. 12 Nov 1873 d. 13 Mar 1911
12
Charles Levi Code
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.2.5]
b. 3 Apr 1876 d. 4 May 1954
12
Ruth Lorena Code
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.2.6]
b. 21 Apr 1880 d. 16 Nov 1939
12
Theda Maria Code
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.2.7]
b. 2 Jul 1883 d. 11 Jun 1932
11
Mary Janet Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.3]
b. 14 Feb 1849 d. Nov 1922
Charles Maynard
b. Abt 1849
12
Charles Maynard
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.3.1]
b. 1880
+
Richard Marlin Wadams
b. 4 Aug 1852 d. 11 Apr 1914
11
George Nelson Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.4]
b. 20 Mar 1851 d. 8 Jun 1912
Annie Baird
b. 5 Nov 1860 d. 1926
12
William Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.4.1]
b. Abt 1883 d. Abt 1888
12
Frank Henry Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.4.2]
b. 6 Dec 1885 d. 5 Sep 1946 [
=>
]
12
Edson George Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.4.3]
b. 25 Apr 1891 d. 4 Mar 1939
12
Ida Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.4.4]
b. Abt 1899 d. 4 Jun 1899
12
Mary Jannett Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.4.5]
b. 16 Apr 1900 d. 3 Aug 1900
12
Edith May Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.4.6]
b. 21 Nov 1903 d. 9 Oct 1945 [
=>
]
11
Edson Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.5]
b. 10 Oct 1853 d. 26 Feb 1909
Mary Ann Beck
b. 13 Jun 1865 d. 16 Jan 1937
12
Mary Magdaline Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.5.1]
b. 8 Oct 1881 d. 24 Feb 1964 [
=>
]
12
Susan Jane Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.5.2]
b. 17 Oct 1883 d. 25 Apr 1965 [
=>
]
12
William Edson Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.5.3]
b. 19 Oct 1885 d. 10 Mar 1976 [
=>
]
12
Luella Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.5.4]
b. 10 Jan 1888 d. 20 Feb 1924 [
=>
]
12
Amy Louisa Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.5.5]
b. 21 Sep 1890 d. 27 Mar 1972 [
=>
]
12
Delilah Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.5.6]
b. 16 Oct 1893 d. 25 Oct 1976 [
=>
]
12
Stanley Dean Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.5.7]
b. 13 Nov 1896 d. 25 Nov 1896
12
Leon Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.5.8]
b. 14 Jul 1899 d. 17 Jul 1966 [
=>
]
12
Vern George Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.5.9]
b. 10 Jan 1902 d. 9 May 1991
12
Kenneth Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.5.10]
b. 13 Jun 1904 d. 4 Apr 1973
11
Harriet Emily Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.6]
b. 21 Nov 1855 d. 4 Oct 1856
11
Annie Bard Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.7]
b. 5 Jun 1856
Susan Ann Gay
b. 13 Jun 1841 d. 29 Sep 1911
11
Martha Ellen Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.8]
b. 19 Jan 1858 d. 20 Oct 1937
Jacob Kesler
b. 30 Sep 1860 d. 25 Dec 1937
12
Hazel Gay Kesler
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.8.1]
b. 2 Apr 1884 d. 20 Dec 1956 [
=>
]
12
Essie Parthenia Kesler
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.8.2]
b. 23 Oct 1885 d. 29 Jul 1935
12
Frederick Nelson Kesler
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.8.3]
b. 22 Oct 1888 d. 13 Nov 1898
12
Dela Von Kesler
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.8.4]
b. 22 Feb 1890 d. 17 Jul 1934
12
Audrey Kesler
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.8.5]
b. 8 Jun 1893 d. 20 Apr 1897
12
Jacob Waldemar Kesler
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.8.6]
b. 23 Jan 1896 d. 8 Feb 1896
12
Martha Ellen Kesler
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.8.7]
b. 10 Sep 1897
11
Nelson Gay Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.9]
b. 21 Sep 1859 d. 2 Apr 1944
Susannah Wanless
b. 25 Apr 1866 d. 5 Jun 1949
12
William Nelson Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.9.1]
b. 22 Dec 1884 d. 30 May 1972 [
=>
]
12
John Gay Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.9.2]
b. 12 May 1887 d. 25 Jan 1949
12
James Anor Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.9.3]
b. 24 Feb 1889 d. 23 Jun 1946 [
=>
]
12
Raymond Leigh Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.9.4]
b. 17 May 1892 d. 9 Sep 1940
12
Marvian Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.9.5]
b. 11 Sep 1896 d. 26 Aug 1898
12
Frederick Dale Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.9.6]
b. 18 Mar 1908 d. 2 Oct 1960
11
Sylvia Gay Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.10]
b. 18 May 1862 d. 20 Jan 1940
Frederick Bateman Margetts
b. 9 Oct 1861 d. 7 Feb 1950
12
Fred Lynn Margetts
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.10.1]
b. 25 Sep 1885 d. 7 Jan 1971
12
Dora Estella Margetts
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.10.2]
b. 5 Mar 1887 d. 24 Jan 1963 [
=>
]
12
Paul Gay Margetts
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.10.3]
b. 12 Dec 1889 d. 6 Apr 1982 [
=>
]
12
Lucille Margetts
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.10.4]
b. 4 Mar 1893 d. 29 Oct 1959
12
Amy Jane Margetts
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.10.5]
b. 4 Oct 1895 d. 19 Feb 1952
12
Susan Ann Margetts
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.10.6]
b. 30 Mar 1898 d. 10 Oct 1995 [
=>
]
12
Anor Whipple Margetts
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.10.7]
b. 28 Feb 1900 d. 15 Apr 1969 [
=>
]
12
Nelson Whipple Margetts
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.10.8]
b. 2 Sep 1903 d. 20 Sep 1962 [
=>
]
11
Susan Ann Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.11]
b. 3 Nov 1864 d. 19 Dec 1935
Archer Walters Clayton
b. 10 Apr 1858 d. 27 Oct 1947
12
Archer Lynne Clayton
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.11.1]
b. 7 Jul 1883 d. 14 Oct 1952 [
=>
]
12
Don Carlos Clayton
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.11.2]
b. 15 Jan 1885 d. 14 Oct 1964 [
=>
]
12
Phyllis Clayton
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.11.3]
b. 29 Jun 1887 d. 13 Aug 1962 [
=>
]
12
Daughter Clayton
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.11.4]
b. 1889
12
Susan Ann Clayton
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.11.5]
b. 24 Dec 1891 d. 8 Jul 1977 [
=>
]
12
Alonzo Hyde Clayton
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.11.6]
b. 25 Apr 1893 d. 12 Apr 1984 [
=>
]
12
Ruth Clayton
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.11.7]
b. 16 Aug 1895 d. 12 May 1896
12
William Arthur Clayton
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.11.8]
b. 30 Aug 1897 d. 28 Jan 1980 [
=>
]
11
Alexander Samuel Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.12]
b. 2 Mar 1867 d. 8 Jan 1899
Sarah "Daisy" Van Natta
b. 8 May 1870 d. 18 Apr 1962
12
Mary Irene Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.12.1]
b. 16 Oct 1891 d. 5 Mar 1989 [
=>
]
12
Ida Jane Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.12.2]
b. 28 Jun 1894 d. 20 Feb 1968
11
Robert John Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.13]
b. 13 Nov 1869 d. 6 Nov 1954
Susie Winn
b. 10 Feb 1874 d. 8 Sep 1963
12
Ora Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.13.1]
b. 6 May 1897 d. 28 Apr 1956
12
Winnie Leath Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.13.2]
b. 21 Sep 1899 d. 23 Jun 1997 [
=>
]
12
Essie June Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.13.3]
b. 27 Jun 1902 d. 3 Jan 1984 [
=>
]
12
Byron John Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.13.4]
b. 15 Mar 1905 d. 19 Aug 1994 [
=>
]
12
Mildred Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.13.5]
b. 16 Nov 1907 d. 7 May 1987
12
Miriam Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.13.6]
b. 16 Nov 1907 d. 29 Jan 1981 [
=>
]
11
Amey Jane Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.14]
b. 15 Dec 1871 d. 6 Sep 1962
John Henry Evans
b. 29 Apr 1872 d. 24 Mar 1947
12
Emerson Whipple Evans
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.14.1]
b. 7 Apr 1901 d. 26 Mar 1973 [
=>
]
12
Alexander Whipple Evans
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.14.2]
b. 4 Aug 1902 d. 20 Apr 1954 [
=>
]
12
John Henry Evans, Jr
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.14.3]
b. 27 Jan 1903 d. 23 Jun 1988 [
=>
]
12
Gwendolyn Whipple Evans
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.14.4]
b. 2 Feb 1904 d. 21 Sep 1986 [
=>
]
12
Amy Evans
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.14.5]
b. 14 Feb 1909 d. 26 Dec 2001
12
Daughter Evans
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.14.6]
b. 20 Sep 1914 d. 20 Sep 1914
11
Ida Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.15]
b. 15 Dec 1873 d. 21 May 1956
Ezra Oakley Taylor
b. 20 May 1863 d. 19 Jul 1952
12
Mary Whipple Taylor
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.15.1]
b. 11 Feb 1897 d. 16 Apr 1953
12
Julia Whipple Taylor
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.15.2]
b. 6 Aug 1900 d. 27 Apr 1989 [
=>
]
12
Ezra Whipple Taylor
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.15.3]
b. 25 May 1904 d. 21 Jul 2001 [
=>
]
12
Ida Gay Taylor
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.15.4]
b. 19 Oct 1908 d. 23 Dec 2001
12
Irvin Whipple Taylor
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.15.5]
b. 16 Jul 1911 d. 4 Jul 1991 [
=>
]
12
Patricia Taylor
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.15.6]
b. 17 Mar 1919 d. 27 Sep 1997
11
Anor Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.16]
b. 25 Mar 1879 d. 23 Oct 1967
Aurilla May Watkins
b. 4 May 1884 d. 18 Apr 1976
12
Aurilla Gay Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.16.1]
b. 20 Aug 1918 d. 5 Mar 2011 [
=>
]
12
Roswell Watkins Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.16.2]
b. 4 Dec 1922 d. 1 Feb 2008
12
Helen Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.16.3]
b. 5 Feb 1926 d. 6 May 2009
Rachel Keeling
b. 10 Mar 1818 d. 16 Jun 1910
11
Daniel Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.17]
b. 12 Apr 1854 d. 12 Feb 1926
Ellen Hirst
b. 3 Feb 1862 d. 21 Dec 1935
12
Daniel LeRoy Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.17.1]
b. 28 Jul 1879 d. 7 Aug 1935 [
=>
]
12
George Wheeler Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.17.2]
b. 4 Aug 1881 d. 30 Sep 1965 [
=>
]
12
John Ernest Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.17.3]
b. 19 Feb 1883 d. 25 Jan 1946
12
Ella Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.17.4]
b. 27 Jan 1884 d. 29 Sep 1935 [
=>
]
12
Leonard Hirst Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.17.5]
b. 7 Jan 1887 d. 11 Nov 1970 [
=>
]
12
Orley Keeling Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.17.6]
b. 6 Apr 1895 d. 24 Sep 1962 [
=>
]
12
Eugene Brook "Dean" Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.17.7]
b. 29 Dec 1899 d. 31 May 1968 [
=>
]
11
Cynthia Delight Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.18]
b. 7 Jun 1857 d. 4 Sep 1858
11
Nelson Wheeler Whipple, Jr
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.19]
b. 15 Apr 1859 d. 30 Jun 1938
Mary Roberts
b. 15 Jul 1857 d. 23 Sep 1935
12
John Wheeler Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.19.1]
b. 19 Oct 1881 d. 3 Aug 1954 [
=>
]
12
Mable Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.19.2]
b. 4 Jul 1883 d. 8 Oct 1951 [
=>
]
12
Rachel Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.19.3]
b. 20 Dec 1885 d. 1 Jul 1886
12
Nelson Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.19.4]
b. 13 Mar 1887 d. 13 Mar 1887
12
Adelaide Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.19.5]
b. 5 May 1888 d. 21 Feb 1898
12
Lawrence Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.19.6]
b. 24 Sep 1891 d. 2 Apr 1934
12
Lillie May Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.19.7]
b. 6 May 1894 d. 20 Dec 1983 [
=>
]
12
Leslie Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.19.8]
b. 1 Oct 1898 d. Oct 1957 [
=>
]
9
Richard Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.3]
b. Abt 1781 d. 25 May 1862
9
Roswell Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.4]
b. 1783 d. 25 May 1862
Melinda Gates
b. 26 May 1802 d. Abt 1827
10
Abram Gates Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.4.1]
b. 19 Oct 1826 d. 1913
Roxanna Weeks
b. Apr 1835 d. 18 Oct 1911
11
Emma E Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.4.1.1]
b. 22 Jan 1854
Hannah Weeks
b. 14 Oct 1806 d. 7 Apr 1889
10
William Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.4.2]
b. Mar 1834 d. Aft Jun 1900
10
Sarah Ann Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.4.3]
b. Abt 16 Feb 1834 d. 18 Jan 1919
10
Clarissa Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.4.4]
b. Feb 1838 d. 30 Jul 1921
10
Ella Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.4.5]
b. Abt 1839
10
Jane Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.4.6]
b. 1843
10
Emoline Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.4.7]
b. Abt 1848 d. 31 Mar 1923
10
Caroline Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.4.8]
b. Abt 1848
10
Frank E Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.4.9]
b. May 1857 d. Aft 1904
9
Polly Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.5]
b. Abt 1785
9
Lucy Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.6]
b. Abt 1787
+
Bingham
b. 1783
9
Cynthia Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.10.7]
b. 1789 d. 15 Feb 1856
Ebenezer Root
b. 17 Dec 1760 d. 12 Feb 1842
10
Jerusha Root
[1.2.1.4.2.1.1.10.7.1]
b. 22 Feb 1804 d. 8 Jul 1889
Seth M Johnson
b. 4 Oct 1802 d. 16 Jun 1865
11
Hiram Titus Johnson
[1.2.1.4.2.1.1.10.7.1.1]
b. May 1829 d. 25 Dec 1852
11
Frances Lucia Johnson
[1.2.1.4.2.1.1.10.7.1.2]
b. 1831
11
Daniel Johnson
[1.2.1.4.2.1.1.10.7.1.3]
b. 21 Apr 1833 d. 1915
Mary Augusta Hale
b. 30 Jul 1833 d. 13 Oct 1889
12
Ellen M Johnson
[1.2.1.4.2.1.1.10.7.1.3.1]
b. 1857
12
Alice J Johnson
[1.2.1.4.2.1.1.10.7.1.3.2]
b. 1860
12
Charles H Johnson
[1.2.1.4.2.1.1.10.7.1.3.3]
b. 1861
12
Mary L Johnson
[1.2.1.4.2.1.1.10.7.1.3.4]
b. 1867
12
F Mary Johnson
[1.2.1.4.2.1.1.10.7.1.3.5]
b. 28 Oct 1873 [
=>
]
11
Charles Johnson
[1.2.1.4.2.1.1.10.7.1.4]
b. 1835
11
Ellen A Johnson
[1.2.1.4.2.1.1.10.7.1.5]
b. 1837 d. 27 Jul 1853
11
Robert L Johnson
[1.2.1.4.2.1.1.10.7.1.6]
b. 1839 d. 18 Nov 1864
11
Mary A Johnson
[1.2.1.4.2.1.1.10.7.1.7]
b. 1842
11
Esther L Johnson
[1.2.1.4.2.1.1.10.7.1.8]
b. 1844
11
Sarah A Johnson
[1.2.1.4.2.1.1.10.7.1.9]
b. 19 Nov 1847
10
Charlotte Root
[1.2.1.4.2.1.1.10.7.2]
b. 5 Jul 1805 d. 26 Oct 1900
Ira Dibble
b. 13 Apr 1795 d. 31 May 1837
11
Ira Wilson Dibble
[1.2.1.4.2.1.1.10.7.2.1]
b. 10 Dec 1827 d. 18 Dec 1902
Sarah Root Bordwell
b. 28 Feb 1834 d. 21 Aug 1895
12
Francelia Dibble
[1.2.1.4.2.1.1.10.7.2.1.1]
b. 16 Apr 1852
12
Cornelia Dibble
[1.2.1.4.2.1.1.10.7.2.1.2]
b. 14 Jul 1856
12
Georgen Lewis Dibble
[1.2.1.4.2.1.1.10.7.2.1.3]
b. 16 Jan 1860
11
William Warner Dibble
[1.2.1.4.2.1.1.10.7.2.2]
b. 10 Dec 1833 d. 24 Oct 1895
Diana Adelia Calkins
b. 1835
12
William Jackson Dibble
[1.2.1.4.2.1.1.10.7.2.2.1]
b. 26 Aug 1868 d. 8 Dec 1947 [
=>
]
10
Polly Root
[1.2.1.4.2.1.1.10.7.3]
b. 16 Apr 1807 d. 9 Dec 1853
10
Daniel W Root
[1.2.1.4.2.1.1.10.7.4]
b. 29 May 1809 d. 23 Oct 1846
10
Harriet Root
[1.2.1.4.2.1.1.10.7.5]
b. 27 Aug 1811 d. 26 Oct 1901
10
Alanson Root
[1.2.1.4.2.1.1.10.7.6]
b. 19 Nov 1814 d. 1817
10
Cyras Root
[1.2.1.4.2.1.1.10.7.7]
b. 10 Feb 1817
10
Silas Root
[1.2.1.4.2.1.1.10.7.8]
b. 10 Feb 1817 d. 1 Apr 1904
8
Thomas Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.11]
b. 16 Mar 1751 d. 1833
Lydia Gates
b. Abt 1761 d. 17 Mar 1795
9
Lydia Gates Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.11.1]
b. 24 Jul 1779 d. 1 Sep 1864
Jonathan Carver Ames
b. 18 Mar 1774 d. 26 Apr 1853
10
Alvin Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.1]
b. 8 Mar 1800 d. 11 Jun 1870
Patricia Ames
b. Abt 1802
11
Hamilton E Aymes
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.1.1]
b. 1828
11
William Ransom Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.1.2]
b. 1831
11
Susan V Aymes
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.1.3]
b. 1841
11
Alvin M Aymes
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.1.4]
b. 1845
11
Jerusa Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.1.5]
10
Chester Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.2]
b. 9 May 1801 d. 28 Aug 1891
Susanna D Pitts
b. 2 Sep 1805 d. 26 Apr 1887
11
Caroline Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.2.1]
b. 3 Oct 1826 d. 17 Apr 1827
11
Lucille A Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.2.2]
b. 22 May 1828 d. 13 May 1909
Thomas William Frazier
b. 29 Jan 1827 d. 2 Apr 1889
12
Susanna Frazier
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.2.2.1]
b. 2 Nov 1852
12
Clarissa F Frazier
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.2.2.2]
b. 30 Apr 1853
12
Jennie Frazier
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.2.2.3]
b. 6 Nov 1854 d. 26 Mar 1929 [
=>
]
12
Theodore Frazier
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.2.2.4]
b. 23 Aug 1859 d. 2 Apr 1889
12
Thomas W Frazier
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.2.2.5]
b. 3 Jun 1866 [
=>
]
11
Apollos Pitts Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.2.3]
b. 22 May 1830 d. 10 Sep 1899
+
Dimis W Webb
b. 1836 d. 1902
11
Thomas Whipple Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.2.4]
b. 10 May 1832 d. 10 Nov 1917
Melissa Melinda Cole
b. Abt 1835
12
Herbert Curtis Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.2.4.1]
b. 18 Aug 1859 d. 9 Sep 1949 [
=>
]
12
Thomas W Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.2.4.2]
b. Abt 1863
12
Alford Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.2.4.3]
b. Abt 1866
12
Apollos Pitt Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.2.4.4]
b. 25 Nov 1868 d. 30 Oct 1948 [
=>
]
12
Lewis H Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.2.4.5]
b. Abt 1871
12
Chester Chandler Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.2.4.6]
b. Oct 1875 d. 1963
12
Cora Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.2.4.7]
b. 1877
11
Alvin Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.2.5]
b. Abt 1834
+
Eliza M Church
11
Olivia L Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.2.6]
b. Aug 1835 d. 28 Dec 1909
Alexander Trotter
b. 3 Jul 1832 d. 4 Jun 1894
12
George Alexander Trotter
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.2.6.1]
b. Jun 1857 d. 5 Apr 1860
12
William Alexander Trotter
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.2.6.2]
b. 4 Aug 1858 d. 3 Jul 1924 [
=>
]
12
Helen S Trotter
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.2.6.3]
b. 15 Aug 1941 d. 1932 [
=>
]
12
Fred Eugene Trotter
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.2.6.4]
b. Jan 1865 d. 5 May 1924
12
Albert Marion Trotter
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.2.6.5]
b. Feb 1866 d. 23 May 1938 [
=>
]
12
Richard Gardner Trotter
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.2.6.6]
b. 1870 [
=>
]
12
Mary Louise Trotter
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.2.6.7]
b. 17 Nov 1872 d. 21 Apr 1926
12
John P Trotter
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.2.6.8]
b. Apr 1875 d. 1940 [
=>
]
12
Lucy Dimis Trotter
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.2.6.9]
b. Jan 1879 d. 14 Sep 1931 [
=>
]
12
Frank Trotter
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.2.6.10]
b. Sep 1871 d. 5 Apr 1860
11
Chester L Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.2.7]
b. 27 Aug 1839 d. 31 Jul 1897
Maria Shepard
b. 5 May 1842 d. 4 Aug 1867
12
James Pitts Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.2.7.1]
b. 8 Jan 1865 d. 1914
12
Son Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.2.7.2]
b. Abt 1867
11
Mary F Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.2.8]
b. 15 Jun 1843 d. 10 Oct 1913
11
Marion Frances Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.2.9]
b. 15 Jun 1843 d. 28 Jun 1924
Ellen F Crawford
b. 10 Sep 1846 d. 28 Jul 1934
12
Marion W Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.2.9.1]
b. Dec 1891 d. 20 Dec 1937 [
=>
]
12
Florence E Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.2.9.2]
b. Abt 1900
11
Benjamin Willard Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.2.10]
b. 16 Feb 1845 d. 1 Oct 1873
+
Hannah Mary Sluman
b. 1850
10
Joseph Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.3]
b. 28 Sep 1802 d. 11 Apr 1851
Rebecca Ames
b. 1815
11
Sally Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.3.1]
b. 1836
11
Simeon Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.3.2]
b. 1841
11
Frederick Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.3.3]
b. 1846
11
Minerva Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.3.4]
b. 1848
10
Mary Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.4]
b. 3 Feb 1804 d. 23 Nov 1884
10
Johnathan Carver Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.5]
b. 18 Apr 1807 d. 26 Mar 1868
Lucy P Ames
b. Abt 1810 d. Mar 1886
11
Jonathan C Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.5.1]
b. 1830
11
Roderick Dhu Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.5.2]
b. 2 Sep 1832 d. 31 Mar 1914
Catharine Barbara Sessler
b. 24 Feb 1842 d. 7 Nov 1925
12
Francelia B Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.5.2.1]
b. 10 Nov 1861 d. 9 Apr 1911 [
=>
]
12
Emma L Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.5.2.2]
b. 9 Oct 1863 d. 27 Jan 1939
12
Philo J Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.5.2.3]
b. 4 Feb 1867 d. 27 Mar 1942 [
=>
]
12
Clarence Edward Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.5.2.4]
b. 26 Sep 1868 d. 15 Nov 1937
12
Roderick Allen Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.5.2.5]
b. 6 Jun 1870 d. 20 Aug 1910
12
Martin H Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.5.2.6]
b. 1 Jan 1872 d. 21 Feb 1886
12
Henry Conrad Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.5.2.7]
b. 10 Aug 1874 d. 18 Aug 1940 [
=>
]
12
Juliann S Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.5.2.8]
b. 15 Oct 1877 d. 1939 [
=>
]
12
John Sessler Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.5.2.9]
b. 5 Sep 1879 d. 18 Aug 1941
11
Samuel E Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.5.3]
b. 27 Dec 1833
10
Thomas Whipple Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.6]
b. 7 Apr 1808 d. 18 Jan 1885
10
Walter Whipple Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.7]
b. 21 Jun 1810 d. 26 Apr 1887
Amelia Stratten
b. 22 Apr 1821 d. 1 Oct 1905
11
Levi F Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.7.1]
b. Mar 1840 d. 16 Jun 1923
11
Albert Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.7.2]
b. 1847
11
Adelbert Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.7.3]
b. 1848
11
Delbert Calvin Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.7.4]
b. 21 Mar 1848 d. 9 Feb 1937
11
Albro Joseph Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.7.5]
b. 21 Mar 1851 d. 14 Nov 1934
11
Josephine Emma Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.7.6]
b. 1853
11
Emily Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.7.7]
b. 1856
10
Caroline Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.8]
b. 1 Apr 1811 d. 17 Apr 1828
10
Valeria Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.9]
b. 24 Jun 1813 d. 15 Sep 1856
10
Levi Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.10]
b. 11 Jun 1816 d. 31 Jul 1909
10
Phoebe Tabor Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.11]
b. 18 Jun 1818
Elijah Ames
b. 23 Feb 1813 d. 10 Nov 1885
11
Lydia W Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.11.1]
b. 1844
Jerome Bonnaparte Story
b. Dec 1840
12
Franklin S Story
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.11.1.1]
b. 5 Sep 1862 d. 15 Oct 1862
12
William A Story
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.11.1.2]
b. 7 Mar 1866 d. 7 Apr 1866
12
Jerome Story
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.11.1.3]
b. 1867
12
William Almon Story
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.11.1.4]
b. 1874 [
=>
]
11
Edmond H Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.11.2]
b. 19 Oct 1846 d. 7 Mar 1917
Ellen B Grandy
b. 18 Mar 1845
12
Fred Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.11.2.1]
b. Aug 1879
11
Rizpah Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.11.3]
b. 8 Oct 1848 d. 18 May 1917
Oscar F Grandy
b. 28 Feb 1842 d. 18 Jan 1901
12
Watie Desire Grandy
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.11.3.1]
b. 17 Jun 1878 d. 10 Oct 1948 [
=>
]
12
Edmond Grandy
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.11.3.2]
b. 11 Jul 1880 d. 5 Jan 1965
12
Leurtus A Grandy
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.11.3.3]
b. 2 Aug 1882 d. 17 Oct 1954
12
Agusta Grandy
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.11.3.4]
b. 6 Jun 1886 d. 28 Dec 1970 [
=>
]
12
Benjamin Harrison Grandy
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.11.3.5]
b. 31 Aug 1888 d. 19 Sep 1971
12
Gertrude Edwina Grandy
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.11.3.6]
b. 1 Nov 1890 d. 5 Mar 1891
12
Raymond Oscar Grandy
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.11.3.7]
b. 1 Nov 1894 d. 27 Dec 1970
11
Truman Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.11.4]
b. 25 Jun 1851 d. 20 Mar 1939
Ella Anna "Nellie" Doyen
b. Oct 1857 d. 1907
12
Jay H Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.11.4.1]
b. Oct 1885 d. Abt 1932
12
Howard T Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.11.4.2]
b. 31 Jul 1887 d. Aft 1939
11
Waittie M Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.11.5]
b. Sep 1854
11
Patsy L Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.11.6]
b. Feb 1858
11
Luella Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.11.7]
b. 6 Jan 1860 d. 10 Oct 1943
10
Lydia Whipple Ames
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.12]
b. 15 Nov 1820 d. 25 Feb 1903
Benjamin F Knowlton
b. 6 Dec 1822 d. 4 Jun 1906
11
George C Knowlton
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.12.1]
b. Oct 1846 d. 14 Oct 1922
Sarah Jane Willard
b. 26 Apr 1850 d. 18 Oct 1923
12
Chester H Knowlton
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.12.1.1]
b. 17 Mar 1876 d. 31 Dec 1952
12
Lulu B Knowlton
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.12.1.2]
b. Abt 1876 [
=>
]
12
Raymond Willard Knowlton
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.12.1.3]
b. 7 Oct 1878 d. 22 Jun 1950 [
=>
]
12
Beulah D Knowlton
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.12.1.4]
b. Mar 1881 [
=>
]
11
Phebe A Knowlton
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.12.2]
b. Oct 1852 d. Jul 1937
Abram M Sherman
b. 26 Apr 1837 d. Jan 1922
12
Clara Sherman
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.12.2.1]
b. May 1874
11
Eugene F Knowlton
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.12.3]
b. Sep 1854 d. 11 May 1938
Laura A Wilcox
b. 20 Jul 1852 d. 4 Apr 1933
12
Abigail Knowlton
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.12.3.1]
b. Jan 1885 d. 1944 [
=>
]
12
Lydia Belle Knowlton
[1.2.1.4.2.1.1.11.1.12.3.2]
b. 19 Oct 1890 d. 29 Sep 1970
9
Thomas Jefferson Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.11.2]
b. 1787 d. 23 Jan 1835
Phebe Taber
b. Aug 1784 d. 17 Aug 1823
10
Alonzo A Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.11.2.1]
b. 27 Feb 1811 d. 11 Mar 1887
Deborah D Parker
b. 1814 d. 11 Aug 1873
11
Thomas D Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.11.2.1.1]
b. Abt 1836 d. Bef 1913
11
Alonzo A Whipple, Jr
[1.2.1.4.2.1.1.11.2.1.2]
b. Abt 1838 d. 13 Jul 1869
Mary E Caykendall
b. Abt 1844 d. 25 Aug 1869
12
Walter A Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.11.2.1.2.1]
b. 1 Jan 1869 d. 17 Sep 1869
11
Rhoda A Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.11.2.1.3]
b. 30 May 1838 d. 28 Aug 1910
James S Smith
b. 27 May 1831 d. 8 Aug 1910
12
Netta D Smith
[1.2.1.4.2.1.1.11.2.1.3.1]
b. 1865
12
Jennie E Smith
[1.2.1.4.2.1.1.11.2.1.3.2]
b. 1869
12
Caroline Smith
[1.2.1.4.2.1.1.11.2.1.3.3]
b. 1 Mar 1873 d. 4 May 1926
12
Effie W Smith
[1.2.1.4.2.1.1.11.2.1.3.4]
b. 11 Aug 1875 d. 16 Feb 1943
11
George F Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.11.2.1.4]
b. Abt 1840 d. Bef 1913
11
Lewis B Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.11.2.1.5]
b. 13 Jun 1842 d. 13 Jul 1867
11
Deborah Parker Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.11.2.1.6]
b. 20 Mar 1845 d. 19 May 1913
Frank Gardner Beaman
b. 7 Feb 1846 d. 13 Nov 1938
12
Charles L'Heureux Beaman
[1.2.1.4.2.1.1.11.2.1.6.1]
b. 15 Jun 1873 d. 1 Sep 1941 [
=>
]
12
Edwin Frank Beaman
[1.2.1.4.2.1.1.11.2.1.6.2]
b. 31 Aug 1875 d. Aft 1941
12
Thomas Whipple Beaman
[1.2.1.4.2.1.1.11.2.1.6.3]
b. 29 Aug 1887 d. Aft 1941
11
Mary Frances Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.11.2.1.7]
b. 1850
+
John A Page
b. 1867
11
Walter G Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.11.2.1.8]
b. Abt 1854 d. Aft 1913
10
Thomas Jefferson Whipple, Jr
[1.2.1.4.2.1.1.11.2.2]
b. 30 Jan 1816 d. 21 Dec 1889
Belinda Butler Hadley
b. 1 May 1820 d. 14 Nov 1854
11
Belinda Caroline Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.11.2.2.1]
b. 18 Aug 1846 d. Aft 1889
George R Somes
b. 13 Dec 1845 d. Aft 1880
12
Gertrude W Somes
[1.2.1.4.2.1.1.11.2.2.1.1]
b. Abt 1869
10
Caroline B Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.11.2.3]
b. 1 Apr 1820 d. 5 Oct 1910
George Flanders
b. 17 May 1822 d. 2 Mar 1895
11
Caroline M Flanders
[1.2.1.4.2.1.1.11.2.3.1]
b. Jan 1851 d. 17 Sep 1851
11
Emily Flanders
[1.2.1.4.2.1.1.11.2.3.2]
b. 19 Jan 1854
9
Mattie Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.11.3]
b. 8 May 1789 d. 4 Sep 1877
Paul Tabor
b. 12 Aug 1788 d. 3 Sep 1878
10
Mialma Tabor
[1.2.1.4.2.1.1.11.3.1]
b. 8 Jan 1814 d. 26 Aug 1894
John Densmore
b. 18 Nov 1805 d. 19 Sep 1851
11
Sarah E Densmore
[1.2.1.4.2.1.1.11.3.1.1]
b. 1838
11
John Densmore
[1.2.1.4.2.1.1.11.3.1.2]
b. 1840
11
Marietta Tabor Densmore
[1.2.1.4.2.1.1.11.3.1.3]
b. 11 Jul 1843 d. 1 Oct 1915
Lewis Cass Judson
b. 3 Sep 1844 d. 16 Dec 1915
12
Thomas Marshall Judson
[1.2.1.4.2.1.1.11.3.1.3.1]
b. 18 Mar 1867 d. 19 Dec 1941 [
=>
]
12
Florence Louise Judson
[1.2.1.4.2.1.1.11.3.1.3.2]
b. 1 Nov 1869 [
=>
]
12
Jessie Alma Judson
[1.2.1.4.2.1.1.11.3.1.3.3]
b. 9 Oct 1872
12
John Lewis Judson
[1.2.1.4.2.1.1.11.3.1.3.4]
b. 4 Jan 1875 d. 1941 [
=>
]
12
Bertie L Judson
[1.2.1.4.2.1.1.11.3.1.3.5]
b. 11 Jul 1878 d. 9 Aug 1878
12
Son Judson
[1.2.1.4.2.1.1.11.3.1.3.6]
b. 27 Apr 1881 d. 2 May 1881
11
Isabella Densmore
[1.2.1.4.2.1.1.11.3.1.4]
b. 1845
11
Amanda Densmore
[1.2.1.4.2.1.1.11.3.1.5]
b. 14 Apr 1848
Lucien Bowen Smith
b. 23 Feb 1843 d. Aft 1893
12
Florence B Smith
[1.2.1.4.2.1.1.11.3.1.5.1]
b. Apr 1868
10
Ann Tabor
[1.2.1.4.2.1.1.11.3.2]
b. 5 Jul 1828 d. 29 Nov 1904
Lucien Bonaparte Bowen
b. 8 Aug 1817 d. 27 Oct 1863
11
Mary Bowen
[1.2.1.4.2.1.1.11.3.2.1]
b. 13 Dec 1848 d. 13 Jan 1849
11
Florence Bowen
[1.2.1.4.2.1.1.11.3.2.2]
b. 31 Jan 1850 d. 31 Dec 1878
+
Frank H Tabor
b. 10 Jul 1850 d. 22 Jan 1879
11
Paul Tabor Bowen
[1.2.1.4.2.1.1.11.3.2.3]
b. 9 Mar 1852
11
George Wood Bowen
[1.2.1.4.2.1.1.11.3.2.4]
b. 4 Mar 1854
11
Laurah Jessie Bowen
[1.2.1.4.2.1.1.11.3.2.5]
b. 30 Jan 1856 d. 15 Jan 1859
11
Annie Patience Bowen
[1.2.1.4.2.1.1.11.3.2.6]
b. 21 Feb 1858
Floyd Thomas Frost
b. 29 Nov 1846
12
Paul Delavan Frost
[1.2.1.4.2.1.1.11.3.2.6.1]
b. 29 Feb 1880
12
Annie May Frost
[1.2.1.4.2.1.1.11.3.2.6.2]
b. 24 Aug 1884
11
Luciene Bowen
[1.2.1.4.2.1.1.11.3.2.7]
b. Dec 1861 d. Jan 1862
9
Son Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.11.4]
b. Bef 1790 d. Aft 1790
9
Walter Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.11.5]
b. 28 Feb 1792 d. 24 Dec 1882
Susan A Donaldson
b. Abt 1795
10
Lothario Danielson Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.11.5.1]
b. 14 Sep 1831 d. 18 Nov 1847
Ruth Baker
b. Abt 1806 d. Aft 1880
10
Susan Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.11.5.2]
b. 1846
10
James Henry Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.11.5.3]
b. Dec 1857
Emma Amelia Packard
b. 9 May 1851 d. 19 May 1939
11
Maggie Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.11.5.3.1]
b. 25 Aug 1871
11
George C Whipple
[1.2.1.4.2.1.1.11.5.3.2]
b. 20 Jul 1875 d. 11 Feb 1922
+
Harriet L Groetzinger
b. Abt 1876
7
Jerusha Jones
[1.2.1.4.2.1.2]
b. 8 Apr 1711 d. 28 Oct 1763
Jonathan Spencer
b. 15 Mar 1704 d. 19 May 1763
8
Jerusha Spencer
[1.2.1.4.2.1.2.1]
b. 6 May 1732 d. 21 Feb 1815
8
Jonathan Spencer
[1.2.1.4.2.1.2.2]
b. 11 Mar 1734 d. 16 Jul 1813
8
Obadiah Spencer
[1.2.1.4.2.1.2.3]
b. 7 Mar 1735 d. 1806
8
Ruth Spencer
[1.2.1.4.2.1.2.4]
b. 12 Feb 1737
8
Israel Spencer
[1.2.1.4.2.1.2.5]
b. 14 Feb 1740 d. 22 Sep 1747
8
Zachariah Spencer
[1.2.1.4.2.1.2.6]
b. 28 Mar 1742 d. 4 Oct 1762
8
Jehid Spencer
[1.2.1.4.2.1.2.7]
b. 17 Feb 1744 d. 16 Sep 1747
8
Jehiel Spencer
[1.2.1.4.2.1.2.8]
b. 17 Feb 1747 d. 24 Feb 1816
8
Israel Spencer
[1.2.1.4.2.1.2.9]
b. Abt 1748 d. 22 Jan 1825
8
Hulda Spencer
[1.2.1.4.2.1.2.10]
b. 7 Jan 1750
8
Sybil Spencer
[1.2.1.4.2.1.2.11]
b. 17 Mar 1759
7
Thomas Jones
[1.2.1.4.2.1.3]
b. 15 Mar 1712 d. 1746
+
Sarah Parsons
b. 10 Mar 1704 d. 25 Aug 1747
7
Bathsheba Jones
[1.2.1.4.2.1.4]
b. 16 Feb 1714 d. 12 May 1715
7
Captain Israel Jones
[1.2.1.4.2.1.5]
b. 18 May 1715 d. 28 Dec 1798
Jemima Clark
b. 5 Mar 1726 d. 3 Jun 1798
8
Israel Jones
[1.2.1.4.2.1.5.1]
b. 2 Sep 1753 d. 1 Sep 1812
8
Jemima Jones
[1.2.1.4.2.1.5.2]
b. 5 Jun 1755 d. 22 Dec 1818
8
Samuel Jones
[1.2.1.4.2.1.5.3]
b. 31 Jan 1745 d. 4 Sep 1747
8
William Clark Jones
[1.2.1.4.2.1.5.4]
b. Abt 1771
8
Thomas Jones
[1.2.1.4.2.1.5.5]
b. 1751 d. 1832
8
Mary Jones
[1.2.1.4.2.1.5.6]
b. Abt 1745 d. Abt 1826
8
Isaac Jones
[1.2.1.4.2.1.5.7]
b. 25 Apr 1764 d. 16 Jul 1830
8
Submit Jones
[1.2.1.4.2.1.5.8]
b. 18 Oct 1757 d. 29 Dec 1785
7
Isaac Jones
[1.2.1.4.2.1.6]
b. 29 Jan 1717 d. 3 Jul 1784
+
Elizabeth
b. Abt 1718
7
Bathsheba Jones
[1.2.1.4.2.1.7]
b. 25 Feb 1720 d. 9 Jan 1775
John Pease
b. 1726 d. Abt 1810
8
John Chauncey Pease
[1.2.1.4.2.1.7.1]
b. Abt 1750 d. 1843
8
Thomas Pease
[1.2.1.4.2.1.7.2]
c. 17 Dec 1754 d. 2 Feb 1810
8
Gideon Pease
[1.2.1.4.2.1.7.3]
b. 18 Nov 1757 d. 1824
8
Elizabeth Pease
[1.2.1.4.2.1.7.4]
b. 29 May 1756 d. 24 Sep 1827
8
Bathsheba Pease
[1.2.1.4.2.1.7.5]
b. 1759
8
Sarah Pease
[1.2.1.4.2.1.7.6]
b. 14 May 1762
8
Simeon Pease
[1.2.1.4.2.1.7.7]
b. Abt 1764 d. 1827
7
Elizabeth Jones
[1.2.1.4.2.1.8]
b. 1722 d. 1804
David Kellogg
b. Abt 1718 d. 6 Mar 1747
8
Mary Kellogg
[1.2.1.4.2.1.8.1]
b. 13 Jun 1748 d. 20 Jun 1810
8
Samuel Kellogg
[1.2.1.4.2.1.8.2]
b. 6 Aug 1749
8
David Kellogg
[1.2.1.4.2.1.8.3]
b. 16 Nov 1750 d. 22 Apr 1774
8
Elizabeth Kellogg
[1.2.1.4.2.1.8.4]
b. 15 Aug 1752 d. 15 Mar 1807
8
Seth Kellogg
[1.2.1.4.2.1.8.5]
b. 14 Mar 1754 d. 20 Jun 1801
8
Phineas Kellogg
[1.2.1.4.2.1.8.6]
b. 6 Apr 1756 d. 26 Jul 1806
8
Ruth Kellogg
[1.2.1.4.2.1.8.7]
b. 3 Sep 1757 d. 14 Jun 1837
8
Enoch Kellogg
[1.2.1.4.2.1.8.8]
b. 12 Jul 1759 d. 31 Aug 1759
8
Elzina Kellogg
[1.2.1.4.2.1.8.9]
b. Abt 1761
8
Lucretia Kellogg
[1.2.1.4.2.1.8.10]
b. Abt 1763 d. 14 Jun 1814
8
Enoch Kellogg
[1.2.1.4.2.1.8.11]
b. 9 Oct 1768 d. 29 Oct 1847
7
Samuel Jones
[1.2.1.4.2.1.9]
b. 29 Oct 1724 d. 19 Sep 1743
+
Anna Taylor
b. Abt 1727
7
Son Jones
[1.2.1.4.2.1.10]
b. Abt 1726
6
Priscilla Jones
[1.2.1.4.2.2]
b. 10 Jun 1681 d. Aft 1719
John Howard
b. 1683
7
Elezebath Howard
[1.2.1.4.2.2.1]
b. 20 May 1707
7
Priscilla Howard
[1.2.1.4.2.2.2]
b. 20 Sep 1705 bur. Abt 1759
7
John Howard
[1.2.1.4.2.2.3]
b. 24 May 1719
6
Benjamin Jones
[1.2.1.4.2.3]
b. 1683 d. 5 Feb 1754
Anna Prior
b. 30 Mar 1690 d. 5 Feb 1754
7
Benjamin Jones
[1.2.1.4.2.3.1]
b. 9 Jun 1710 d. 13 Oct 1794
7
Joseph Jones
[1.2.1.4.2.3.2]
b. 3 Jan 1712 d. 26 Jan 1757
Sarah Wood
b. Abt 1712
8
Joseph Jones
[1.2.1.4.2.3.2.1]
b. 1 Nov 1734 d. 29 Jan 1816
Sarah Mead
b. 10 Aug 1735 d. 21 Dec 1822
9
Thomas Jones
[1.2.1.4.2.3.2.1.1]
b. 1762 d. 25 Jul 1842
Susanna Susan Ramsey
b. 1770 d. 1851
10
Susanne Jones
[1.2.1.4.2.3.2.1.1.1]
b. 1789
10
Mary Jones
[1.2.1.4.2.3.2.1.1.2]
b. 1792
10
Esquire M Jones
[1.2.1.4.2.3.2.1.1.3]
b. 1792 d. 1891
10
Rebecca Jones
[1.2.1.4.2.3.2.1.1.4]
b. 1795 d. 1880
10
Elizabeth Jones
[1.2.1.4.2.3.2.1.1.5]
b. 1798 d. 1880
10
Daniel Jones
[1.2.1.4.2.3.2.1.1.6]
b. 1802
10
William Jones
[1.2.1.4.2.3.2.1.1.7]
b. 10 Feb 1800 d. 1850
Artymes Johannes
b. 22 Aug 1802 d. 3 Oct 1884
11
William H Jones
[1.2.1.4.2.3.2.1.1.7.1]
b. 17 Nov 1824 d. 13 Jun 1909
Martha J Latcher
b. 11 Jan 1834 d. 22 Nov 1879
12
Shelby Elliot Jones
[1.2.1.4.2.3.2.1.1.7.1.1]
b. 30 Nov 1854 d. 4 Dec 1913 [
=>
]
11
George Washington Jones
[1.2.1.4.2.3.2.1.1.7.2]
b. May 1827 d. 13 Nov 1903
11
Andrew Jackson Jones
[1.2.1.4.2.3.2.1.1.7.3]
b. Abt 1832 d. 20 Apr 1907
11
Nancy Jones
[1.2.1.4.2.3.2.1.1.7.4]
b. Abt 1834 d. Abt 1866
11
Leander David Jones
[1.2.1.4.2.3.2.1.1.7.5]
b. 22 Nov 1838 d. 26 Feb 1925
Ann Elizabeth Waters
b. Mar 1845
12
Hattie V Jones
[1.2.1.4.2.3.2.1.1.7.5.1]
b. Abt 1873 d. 1895
11
Francis Marion Jones
[1.2.1.4.2.3.2.1.1.7.6]
b. 1 Jan 1841 d. 17 Apr 1933
Annie Elizabeth Parthine Morris
b. 18 May 1846 d. 12 Dec 1931
12
Tennessee Jones
[1.2.1.4.2.3.2.1.1.7.6.1]
b. 28 Feb 1867 d. 9 Feb 1931
12
Virginia Jones
[1.2.1.4.2.3.2.1.1.7.6.2]
b. 6 Jun 1868 d. 9 Nov 1955
12
Sally Jones
[1.2.1.4.2.3.2.1.1.7.6.3]
b. May 1870 d. 24 Jun 1917
12
Mary Jones
[1.2.1.4.2.3.2.1.1.7.6.4]
b. 1873 d. 1880
12
Jonas Hardy Jones
[1.2.1.4.2.3.2.1.1.7.6.5]
b. 15 Feb 1876 d. 19 May 1936 [
=>
]
12
Plummer J Jones
[1.2.1.4.2.3.2.1.1.7.6.6]
b. 15 Apr 1877 d. 16 Oct 1968
12
Margaret Jones
[1.2.1.4.2.3.2.1.1.7.6.7]
b. 18 May 1877 d. 5 Jan 1952
12
Lutisha Jones
[1.2.1.4.2.3.2.1.1.7.6.8]
b. 1 Oct 1881 d. 27 Nov 1947
12
Christine Jones
[1.2.1.4.2.3.2.1.1.7.6.9]
b. 15 Jun 1884 d. 29 Nov 1968
12
Nancy Belle Jones
[1.2.1.4.2.3.2.1.1.7.6.10]
b. 1 Oct 1885 d. 26 Feb 1963
12
Henry Calvin Jones
[1.2.1.4.2.3.2.1.1.7.6.11]
b. 4 Oct 1887 d. 23 Jan 1948 [
=>
]
12
William Ira Jones
[1.2.1.4.2.3.2.1.1.7.6.12]
b. 18 Feb 1889 d. 27 Oct 1951 [
=>
]
12
Rosa Lucy Jones
[1.2.1.4.2.3.2.1.1.7.6.13]
b. 17 Nov 1893 d. 17 Mar 1960
11
Susan Ellen Jones
[1.2.1.4.2.3.2.1.1.7.7]
b. 5 Mar 1843 d. 6 Sep 1919
William W Crumley
b. 19 Apr 1839 d. 5 Nov 1916
12
Nancy Crumley
[1.2.1.4.2.3.2.1.1.7.7.1]
b. Abt 1862 d. Abt 1867
12
Williams Crumley
[1.2.1.4.2.3.2.1.1.7.7.2]
b. 29 Apr 1863 d. 9 Aug 1954 [
=>
]
12
John A Crumley
[1.2.1.4.2.3.2.1.1.7.7.3]
b. Abt 1865
12
James M. Crumley
[1.2.1.4.2.3.2.1.1.7.7.4]
b. 1869
12
Artse A Crumley
[1.2.1.4.2.3.2.1.1.7.7.5]
b. 4 Jun 1873 d. 14 May 1913
12
Elizabeth A Crumley
[1.2.1.4.2.3.2.1.1.7.7.6]
b. 7 Jun 1876 [
=>
]
12
Delia M Crumley
[1.2.1.4.2.3.2.1.1.7.7.7]
b. Abt 1878
11
Marshall Bruce Jones
[1.2.1.4.2.3.2.1.1.7.8]
b. 9 Feb 1846 d. 8 Mar 1885
Mary Jane Warren
b. 22 Feb 1848 d. 19 Sep 1923
12
Abner Canier Jones
[1.2.1.4.2.3.2.1.1.7.8.1]
b. 7 Jun 1871 d. 12 Jun 1945 [
=>
]
12
Nettie Ellen Jones
[1.2.1.4.2.3.2.1.1.7.8.2]
b. 7 Dec 1873 d. 9 Jul 1958 [
=>
]
12
Kittsmillen Jones
[1.2.1.4.2.3.2.1.1.7.8.3]
b. Abt 1877
12
Ida Mae Jones
[1.2.1.4.2.3.2.1.1.7.8.4]
b. 21 Jun 1876 d. 13 Jun 1965 [
=>
]
12
William Harrison Jones
[1.2.1.4.2.3.2.1.1.7.8.5]
b. 24 Dec 1878 d. 15 May 1951 [
=>
]
12
James Garfield Jones
[1.2.1.4.2.3.2.1.1.7.8.6]
b. 1880 d. 1881
12
Jeannette Jones
[1.2.1.4.2.3.2.1.1.7.8.7]
b. 1882 d. 1883
12
Everett Bruce Jones
[1.2.1.4.2.3.2.1.1.7.8.8]
b. 10 Sep 1884 d. 12 May 1958 [
=>
]
10
John Ramsey Jones
[1.2.1.4.2.3.2.1.1.8]
b. 17 Nov 1806 d. 1880
Catherine Morrell
b. Abt 1808
11
Montraville Jones
[1.2.1.4.2.3.2.1.1.8.1]
b. 1832
11
Charlotte Jones
[1.2.1.4.2.3.2.1.1.8.2]
b. 1834 d. 20 May 1926
11
Squire M. Jones
[1.2.1.4.2.3.2.1.1.8.3]
b. Sep 1835 d. 28 Dec 1905
10
Stacy Jones
[1.2.1.4.2.3.2.1.1.9]
b. 1805 d. 1849
10
Eliza Jones
[1.2.1.4.2.3.2.1.1.10]
b. 1809
10
Catherine Jones
[1.2.1.4.2.3.2.1.1.11]
b. 1811 d. 1885
8
Tryphena Jones
[1.2.1.4.2.3.2.2]
b. 22 Mar 1737
8
Silas Jones
[1.2.1.4.2.3.2.3]
b. 1 Apr 1740
8
Daniel Jones
[1.2.1.4.2.3.2.4]
b. 31 Jan 1743 d. 23 Mar 1792
8
Esther Jones
[1.2.1.4.2.3.2.5]
b. Abt 1757 d. 1821
7
Annie Jones
[1.2.1.4.2.3.3]
b. 9 Sep 1714 d. 22 Sep 1808
7
Levi Jones
[1.2.1.4.2.3.4]
b. 9 Nov 1716 d. 23 May 1766
7
Abi Jones
[1.2.1.4.2.3.5]
b. 15 Mar 1718
7
Hannah Jones
[1.2.1.4.2.3.6]
b. 23 Sep 1720 d. 11 Oct 1806
7
Naomi Jones
[1.2.1.4.2.3.7]
b. 28 Mar 1721
7
Zebblon Jones
[1.2.1.4.2.3.8]
b. 9 Jun 1723 d. 27 Sep 1776
7
Lucrettia Jones
[1.2.1.4.2.3.9]
b. 1729
6
Ebenezer Jones
[1.2.1.4.2.4]
b. 17 Apr 1684 d. 20 Jul 1755
Priscilla Smith
b. Abt 1684 d. Bef 1725
7
Elezebath Jones
[1.2.1.4.2.4.1]
b. 11 May 1713
7
Ebenezer Jones
[1.2.1.4.2.4.2]
b. 12 Jan 1715
7
Gersham Jones
[1.2.1.4.2.4.3]
b. 1717
7
Hannah Jones
[1.2.1.4.2.4.4]
b. 11 Jul 1720 d. 8 Jul 1764
7
Martha Jones
[1.2.1.4.2.4.5]
b. Abt 1721
Jemima Gary
b. 10 Mar 1705 d. Aft 1747
7
North Jones
[1.2.1.4.2.4.6]
b. 18 Apr 1731
7
Zerviah Jones
[1.2.1.4.2.4.7]
b. 28 Mar 1734
7
Abigail Jones
[1.2.1.4.2.4.8]
b. 4 Jan 1735
7
Nathan Jones
[1.2.1.4.2.4.9]
b. Jun 1738
7
Thomas Jones
[1.2.1.4.2.4.10]
b. 30 Aug 1741 d. 13 Oct 1762
7
Margan Jones
[1.2.1.4.2.4.11]
b. 8 Aug 1747
6
Elizabeth Jones
[1.2.1.4.2.5]
b. 26 Jan 1685 d. 2 Jan 1769
Isaac Osborn
b. Abt 1680
7
George Osborn
[1.2.1.4.2.5.1]
c. 20 Oct 1724
6
Ephraim Jones
[1.2.1.4.2.6]
b. 31 Jul 1688 d. 3 Sep 1688
6
Samuel Jones
[1.2.1.4.2.7]
b. 22 Sep 1690 d. 4 Nov 1691
6
Eleazer Jones
[1.2.1.4.2.8]
b. 12 Apr 1693 d. 20 Apr 1755
Mehitable Gary
b. 11 Jul 1697 d. Aft 1735
7
Son Jones
[1.2.1.4.2.8.1]
b. 21 May 1721 d. 26 Jun 1721
7
Eleazer Jones
[1.2.1.4.2.8.2]
b. 26 Jan 1723 d. 23 May 1758
7
Mehitable Jones
[1.2.1.4.2.8.3]
b. 4 Jun 1725 d. 28 Apr 1766
7
Elizabeth Jones
[1.2.1.4.2.8.4]
b. 23 Jul 1727 d. 28 Apr 1766
7
Benjamin Jones
[1.2.1.4.2.8.5]
b. 8 May 1730
7
Ebenezer Jones
[1.2.1.4.2.8.6]
6
Gersham Jones
[1.2.1.4.2.9]
b. 26 Oct 1695 d. 19 Oct 1696
5
Priscilla Wildes
[1.2.1.4.3]
b. 6 Apr 1658 d. 23 Mar 1688
5
Martha Wildes
[1.2.1.4.4]
b. 13 May 1660 d. 1685
5
Nathan Wildes
[1.2.1.4.5]
b. 14 Dec 1662 d. 17 Mar 1663
4
John Gould
[1.2.1.5]
b. 21 Jun 1635 d. 26 Jan 1710
Sarah Baker
b. 9 Mar 1641 d. 20 Jan 1709
5
John Gould
[1.2.1.5.1]
b. 1 Dec 1662 d. 5 Nov 1724
5
Sarah Gould
[1.2.1.5.2]
b. 18 Dec 1664 d. 4 Dec 1723
5
Thomas Gould
[1.2.1.5.3]
b. 14 Feb 1666 d. 24 Jun 1752
5
Samuel Gould
[1.2.1.5.4]
b. 9 Mar 1669 d. 1 Dec 1724
5
Zaccheus Gould
[1.2.1.5.5]
b. 26 Mar 1672 d. 29 Apr 1739
Elizabeth Curtis
b. 15 Dec 1679 d. 21 Jun 1740
6
Elizabeth Gould
[1.2.1.5.5.1]
b. 3 Feb 1703 d. 17 Sep 1742
Edmund Towne
b. 7 May 1699 d. 27 May 1745
7
Eliza Goold
[1.2.1.5.5.1.1]
b. 29 Dec 1723
7
Debora Goold
[1.2.1.5.5.1.2]
b. Abt 1724 d. 12 Mar 1812
7
Mehitabel Goold
[1.2.1.5.5.1.3]
b. 10 Nov 1728
7
Edmund Towne
[1.2.1.5.5.1.4]
b. 10 Sep 1733
7
Nathaniel Gould
[1.2.1.5.5.1.5]
b. 17 Nov 1734 d. Dec 1781
7
Zaccheus Town
[1.2.1.5.5.1.6]
b. 20 Feb 1736 d. 1740
7
Bathsheba Towne
[1.2.1.5.5.1.7]
b. 28 Mar 1740 d. 1741
7
Mary Towne
[1.2.1.5.5.1.8]
b. 7 Sep 1742 d. 1742
6
Mary Gould
[1.2.1.5.5.2]
c. 1 Mar 1704 d. 3 Nov 1787
6
John Gould
[1.2.1.5.5.3]
b. 29 Jan 1709 d. 21 Jun 1778
6
Sarah Gould
[1.2.1.5.5.4]
b. 28 Jan 1711 d. 1743
6
Abigail Gould
[1.2.1.5.5.5]
b. 12 Aug 1715 d. Abt 1737
6
Zaccheus Gould
[1.2.1.5.5.6]
b. 7 Nov 1717 d. 2 Jan 1793
6
Eleazar Gould
[1.2.1.5.5.7]
b. 29 May 1720 d. Jun 1795
Elizabeth Smith
b. 8 Jul 1718 d. 27 Mar 1753
7
Zaccheus Gould
[1.2.1.5.5.7.1]
b. 5 Feb 1743 d. 13 Feb 1823
7
John Gould
[1.2.1.5.5.7.2]
b. 5 Mar 1745
7
Hulda Gould
[1.2.1.5.5.7.3]
b. 1 Aug 1748 d. 11 Oct 1748
6
Susannah Gould
[1.2.1.5.5.8]
b. 19 Feb 1723 d. Abt 1773
Robert Smith
b. 28 Feb 1724 d. 17 Mar 1795
7
Elijah Smith
[1.2.1.5.5.8.1]
b. 5 Dec 1746 d. 5 Nov 1839
7
Elisha Smith
[1.2.1.5.5.8.2]
b. 4 Oct 1748
7
Joseph Smith
[1.2.1.5.5.8.3]
b. 9 Jun 1751
7
Elizabeth Smith
[1.2.1.5.5.8.4]
b. 20 Apr 1753 d. 10 Apr 1797
7
Rebeckah Smith
[1.2.1.5.5.8.5]
b. 8 May 1758 d. 8 Sep 1839
7
Thomas Smith
[1.2.1.5.5.8.6]
b. 10 Mar 1760 d. 3 Oct 1846
7
Silas Smith
[1.2.1.5.5.8.7]
b. 30 May 1772
7
Jedediah Smith
[1.2.1.5.5.8.8]
b. 30 May 1772
6
Priscilla Gould
[1.2.1.5.5.9]
b. 4 Aug 1707 d. 25 Sep 1744
Captain Samuel T Smith
b. 26 Jan 1714 d. 14 Nov 1785
7
Priscilla Smith
[1.2.1.5.5.9.1]
b. 26 Dec 1735 d. 7 Dec 1792
Jacob Kimball
b. 5 Mar 1731 d. 8 Nov 1810
8
Benjamin Kimball
[1.2.1.5.5.9.1.1]
b. 23 Jan 1757 d. 19 Aug 1776
8
Mehetiball Kimbal
[1.2.1.5.5.9.1.2]
b. 3 Dec 1758 d. 12 Nov 1790
8
Jacob Kimball
[1.2.1.5.5.9.1.3]
b. 2 Feb 1761 d. 24 Jul 1826
8
Priscilla Kimball
[1.2.1.5.5.9.1.4]
b. 10 Mar 1763 d. 2 Sep 1792
8
Ann Kimball
[1.2.1.5.5.9.1.5]
b. 2 Jun 1765 d. 12 Sep 1789
8
Lucy Kimball
[1.2.1.5.5.9.1.6]
b. 6 Sep 1767 bur. Sep 1790
8
Lydia Kimball
[1.2.1.5.5.9.1.7]
b. 28 Jan 1770 d. 20 Apr 1795
8
David Kimball
[1.2.1.5.5.9.1.8]
b. 26 Apr 1772 d. 20 Nov 1795
8
Samuel Kimball
[1.2.1.5.5.9.1.9]
b. Dec 1774 d. 10 Sep 1775
7
Samuel Smith, III
[1.2.1.5.5.9.2]
b. 28 Oct 1737 d. 14 Nov 1785
Rebecca Lovett
b. 9 Jun 1737 d. Aft 1760
8
Rebekah Smith
[1.2.1.5.5.9.2.1]
b. 29 Jun 1760 d. 15 Apr 1816
8
Lydia Smith
[1.2.1.5.5.9.2.2]
b. 14 Apr 1762 d. 19 Dec 1850
Jacob Wilds
b. Abt 1780 d. 16 Jan 1841
9
Mary Wilds
[1.2.1.5.5.9.2.2.1]
b. Sep 1787 d. 29 Feb 1856
9
Moses Wilds
[1.2.1.5.5.9.2.2.2]
b. 8 Oct 1790 d. 1 Nov 1879
Abigail King
b. 10 Jun 1800 d. 25 Aug 1887
10
Mary Wilds
[1.2.1.5.5.9.2.2.2.1]
b. 14 Feb 1818 d. 21 Apr 1895
Nathan A Smith
b. 12 Feb 1820 d. 11 Apr 1888
11
Lydia Smith
[1.2.1.5.5.9.2.2.2.1.1]
b. 4 Aug 1847 d. 22 Nov 1937
+
George B Holbrook
b. 24 Jun 1855 d. 6 May 1926
11
Carlos William Smith
[1.2.1.5.5.9.2.2.2.1.2]
b. 18 Aug 1852 d. 2 May 1928
+
Sarah Clark
b. Abt 1863 d. 1885/1895
Mertie May Smith Loomis
b. 11 Apr 1861 d. 11 Sep 1925
12
Flora Winifred Smith
[1.2.1.5.5.9.2.2.2.1.2.1]
b. 16 Jan 1897 d. 7 Jul 1966 [
=>
]
12
Monroe William Smith
[1.2.1.5.5.9.2.2.2.1.2.2]
b. 22 Jan 1901 d. 8 Dec 1972 [
=>
]
10
Lydia Wilds
[1.2.1.5.5.9.2.2.2.2]
b. 4 Feb 1820
Thomas Jefferson Dickey
b. 10 Dec 1808 d. 1 Feb 1881
11
Henry Dickey
[1.2.1.5.5.9.2.2.2.2.1]
b. 1842 d. 1913
11
Clara Ellen Dickey
[1.2.1.5.5.9.2.2.2.2.2]
b. 5 Apr 1849 d. 15 Jun 1877
John Sawyer
b. Jul 1836 d. 20 Jul 1913
12
Son Sawyer
[1.2.1.5.5.9.2.2.2.2.2.1]
b. 30 Sep 1867
12
Carrie Ella Sawyer
[1.2.1.5.5.9.2.2.2.2.2.2]
b. 6 Jan 1871 d. 21 Nov 1961
12
Daughter Sawyer
[1.2.1.5.5.9.2.2.2.2.2.3]
b. 25 Jan 1876 d. 24 Mar 1876
11
Thomas Jefferson Dickey, Jr
[1.2.1.5.5.9.2.2.2.2.3]
b. 26 Jan 1850 d. 26 Mar 1865
11
Rose A Dickey
[1.2.1.5.5.9.2.2.2.2.4]
b. 22 Jan 1854 d. 22 Mar 1874
11
Lillian Dickey
[1.2.1.5.5.9.2.2.2.2.5]
b. 29 Sep 1859
10
Mehitable "Hittie" Wilds
[1.2.1.5.5.9.2.2.2.3]
b. 17 Jun 1826 d. 1 Nov 1910
Richard Peckham Church
b. 27 Nov 1819 d. 27 Nov 1897
11
George King Church
[1.2.1.5.5.9.2.2.2.3.1]
b. 1 May 1844 d. 1937
Lydia R Cilley
b. 22 Jul 1842 d. 12 Oct 1908
12
Martha L Church
[1.2.1.5.5.9.2.2.2.3.1.1]
b. 1 Sep 1866
12
Lena May Church
[1.2.1.5.5.9.2.2.2.3.1.2]
b. 7 Nov 1877
11
Lydia Church
[1.2.1.5.5.9.2.2.2.3.2]
b. 1846
11
Flora Church
[1.2.1.5.5.9.2.2.2.3.3]
b. Abt 30 Apr 1856 d. 31 Aug 1859
11
Floran A Church
[1.2.1.5.5.9.2.2.2.3.4]
b. 15 May 1859 d. 14 Dec 1931
Hannah E Smith
b. Mar 1863
12
Hilas Bathelder Church
[1.2.1.5.5.9.2.2.2.3.4.1]
b. 9 Sep 1882
12
Etta Bell Church
[1.2.1.5.5.9.2.2.2.3.4.2]
b. 23 Apr 1886
12
George Elwood Church
[1.2.1.5.5.9.2.2.2.3.4.3]
b. Abt 5 Jun 1888 d. 10 Jul 1889
12
Kenneth Clyde Church
[1.2.1.5.5.9.2.2.2.3.4.4]
b. 9 Jun 1890
10
Sally J Wilds
[1.2.1.5.5.9.2.2.2.4]
b. Abt 1828
Christopher Columbus Payne
b. 28 Sep 1828 d. 1 Dec 1883
11
Wilson A Payne
[1.2.1.5.5.9.2.2.2.4.1]
b. 1851 d. 1926
+
Rhoda E Daya
b. 1847
11
Abbie S Payne
[1.2.1.5.5.9.2.2.2.4.2]
b. 1854
John Flanders
12
John Flanders
[1.2.1.5.5.9.2.2.2.4.2.1]
b. 1878 d. 25 Dec 1949
11
Dwight C Payne
[1.2.1.5.5.9.2.2.2.4.3]
b. May 1868 d. 4 Apr 1870
10
Cynthia C Wilds
[1.2.1.5.5.9.2.2.2.5]
b. 30 Aug 1831 d. 26 May 1930
+
Samuel G Saville
b. 28 Nov 1828 d. 1 Dec 1918
9
Asa Wilds
[1.2.1.5.5.9.2.2.3]
b. Abt 1795 d. Abt 1831
9
Nancy Wilds
[1.2.1.5.5.9.2.2.4]
b. 12 May 1798 d. 4 Dec 1884
9
William Wilds
[1.2.1.5.5.9.2.2.5]
b. 16 Jan 1800 d. 16 Feb 1876
Sarah King
b. 19 Jan 1804 d. 13 Mar 1866
10
Diantha Wilds
[1.2.1.5.5.9.2.2.5.1]
b. 2 Dec 1831
Aaron Bunnell Sargent
b. 7 Jun 1829
11
Mary S Sargent
[1.2.1.5.5.9.2.2.5.1.1]
b. 24 Jun 1852 d. 19 Apr 1902
Azariah Barnes
b. Nov 1841 d. Aft 1880
12
Ethel Rosamond Barnes
[1.2.1.5.5.9.2.2.5.1.1.1]
b. 4 Aug 1873 d. 6 Jun 1947 [
=>
]
12
Katie Alice Barnes
[1.2.1.5.5.9.2.2.5.1.1.2]
b. 12 Sep 1875
12
Wilford A Barnes
[1.2.1.5.5.9.2.2.5.1.1.3]
b. 1881 d. 11 Nov 1900
12
Minnie May Barnes
[1.2.1.5.5.9.2.2.5.1.1.4]
b. 9 Jan 1886 d. 9 Oct 1965 [
=>
]
12
Vernie Mildred Barnes
[1.2.1.5.5.9.2.2.5.1.1.5]
b. 16 Oct 1892
12
Nellie D Barnes
[1.2.1.5.5.9.2.2.5.1.1.6]
b. 28 Oct 1878 d. 26 May 1941 [
=>
]
10
Diana Wilds
[1.2.1.5.5.9.2.2.5.2]
b. 2 Dec 1831
Almon Richardson Thurston
b. Abt 1829
11
Emma Thurston
[1.2.1.5.5.9.2.2.5.2.1]
b. 1858
11
Claira C. Thurston
[1.2.1.5.5.9.2.2.5.2.2]
b. 28 Jun 1859
10
Merrill F Wilds
[1.2.1.5.5.9.2.2.5.3]
b. 23 Dec 1832 d. 27 Jul 1903
Satira Bradford
b. Abt 10 Apr 1842 d. 20 Oct 1897
11
Etta May Wilds
[1.2.1.5.5.9.2.2.5.3.1]
b. 21 Jun 1866 d. 22 Dec 1933
Charles Colburn Lord
b. 29 Aug 1864 d. 20 Dec 1944
12
Ralph Christie Lord
[1.2.1.5.5.9.2.2.5.3.1.1]
b. 19 May 1890 d. 5 Feb 1969
12
Wendell E Lord
[1.2.1.5.5.9.2.2.5.3.1.2]
b. 19 Aug 1894 d. 8 Nov 1918
12
Merle E Lord
[1.2.1.5.5.9.2.2.5.3.1.3]
b. 12 Apr 1900 d. 29 Apr 1900
12
Charles Delwin Lord
[1.2.1.5.5.9.2.2.5.3.1.4]
b. 6 Aug 1902 d. 13 Nov 1997
12
Alice Etta Lord
[1.2.1.5.5.9.2.2.5.3.1.5]
b. 19 Jan 1905 d. 12 May 1998
11
Rosie Emma Wilds
[1.2.1.5.5.9.2.2.5.3.2]
b. 21 Apr 1870 d. 27 Dec 1903
Edward D Cook
b. 1865 d. 1935
12
Nellie Cook
[1.2.1.5.5.9.2.2.5.3.2.1]
b. 14 Sep 1897 d. Jun 1983
12
Helen Almina Cook
[1.2.1.5.5.9.2.2.5.3.2.2]
b. 30 Oct 1903 d. 18 May 1931
10
Sarah King Wilds
[1.2.1.5.5.9.2.2.5.4]
b. 2 May 1834 d. 29 Jan 1906
Charles Poole
b. Abt 1830 d. 27 Jan 1906
11
Edward C Poole
[1.2.1.5.5.9.2.2.5.4.1]
b. 1 Nov 1854
11
Ada M Poole
[1.2.1.5.5.9.2.2.5.4.2]
b. 9 Nov 1856 d. 18 Jul 1890
+
Martin luther Sanborn
b. 1852
11
Gertrude S Poole
[1.2.1.5.5.9.2.2.5.4.3]
b. 21 Jun 1863
Walter P Bugbee
b. Abt 1860
12
Orpha P Bugbee
[1.2.1.5.5.9.2.2.5.4.3.1]
b. 22 Apr 1884
12
Charles L Bugbee
[1.2.1.5.5.9.2.2.5.4.3.2]
b. 27 Jun 1886
11
William Everett Poole
[1.2.1.5.5.9.2.2.5.4.4]
b. 13 Jun 1867
+
Hattie L Miller
b. 1871
10
Louisa Wilds
[1.2.1.5.5.9.2.2.5.5]
b. 13 Dec 1838 d. 26 Dec 1893
Alexander Franklin Hayward
b. 11 Apr 1836 d. 4 Jul 1911
11
Ernest Franklin Hayward
[1.2.1.5.5.9.2.2.5.5.1]
b. 1 Oct 1874 d. 17 May 1951
Jennie May Taplin
b. 27 May 1887 d. 6 Feb 1972
12
Vernon Edward Hayward
[1.2.1.5.5.9.2.2.5.5.1.1]
b. 26 Jan 1908 d. 20 Oct 1978
12
Merlin Franklin Hayward
[1.2.1.5.5.9.2.2.5.5.1.2]
b. 17 Mar 1909 d. 3 Dec 1974 [
=>
]
10
Almira Elizabeth Wilds
[1.2.1.5.5.9.2.2.5.6]
b. 11 Sep 1840 d. 21 Feb 1906
Charles Howard Beede
b. 3 Aug 1839 d. 4 Apr 1911
11
Clinton Horatio Beede
[1.2.1.5.5.9.2.2.5.6.1]
b. 11 Jan 1865 d. 19 Mar 1942
+
Besse Viola Jefferds
b. 24 Sep 1880 d. 30 Jan 1964
Ethel Winifred Ladd
b. 6 Sep 1877 d. 7 May 1920
12
Kenneth Charles Beede
[1.2.1.5.5.9.2.2.5.6.1.1]
b. 22 Nov 1898 d. 5 Mar 1961
12
Inez Winifred Beede
[1.2.1.5.5.9.2.2.5.6.1.2]
b. 7 Feb 1900 d. 29 Dec 1978
12
Velma Ladd Beede
[1.2.1.5.5.9.2.2.5.6.1.3]
b. 30 Jan 1903 d. 1984
11
Caroline Adell Beede
[1.2.1.5.5.9.2.2.5.6.2]
b. 28 Apr 1868 d. 12 Sep 1934
Charles N Wales
b. 1864
12
Almira Wales
[1.2.1.5.5.9.2.2.5.6.2.1]
b. Abt 1890
12
Eva May Wales
[1.2.1.5.5.9.2.2.5.6.2.2]
b. Nov 1891
+
Lester Sanborn
b. Abt 1864
11
Rose Emma Beede
[1.2.1.5.5.9.2.2.5.6.3]
b. 1 Nov 1871 d. 17 Nov 1919
Frank Matthew Allen
b. 1865 d. 17 Nov 1919
12
Florence Allen
[1.2.1.5.5.9.2.2.5.6.3.1]
b. 20 Jun 1893
12
Russell Allen
[1.2.1.5.5.9.2.2.5.6.3.2]
b. 5 Jan 1897
12
Sheldon Chancey Allen
[1.2.1.5.5.9.2.2.5.6.3.3]
b. 23 Dec 1900 d. 4 Jan 1996
11
Bertha Alice Beede
[1.2.1.5.5.9.2.2.5.6.4]
b. 22 Oct 1877 d. 27 May 1932
Chauncy Elmer Bixby
b. 14 Sep 1874
12
Velma Christina Bixby
[1.2.1.5.5.9.2.2.5.6.4.1]
b. 25 Mar 1904 d. 1997
11
Ada May Beede
[1.2.1.5.5.9.2.2.5.6.5]
b. 26 May 1881 d. 13 Aug 1881
10
John K Wilds
[1.2.1.5.5.9.2.2.5.7]
d. 5 Feb 1909
Eunice M Dexter
b. 17 Feb 1831 d. 29 May 1898
11
Elwin Aaron Wilds
[1.2.1.5.5.9.2.2.5.7.1]
b. 9 Dec 1859 d. 2 Jul 1932
Mary Tabitha Courtney
b. 26 Nov 1870 d. 13 Jul 1901
12
Pearl Elisabeth Wilds
[1.2.1.5.5.9.2.2.5.7.1.1]
b. 13 May 1884 d. 16 Feb 1973 [
=>
]
12
Roy Elwin Wilds
[1.2.1.5.5.9.2.2.5.7.1.2]
b. 11 Apr 1892 d. 18 Aug 1975 [
=>
]
12
Ralph Oscar Wilds
[1.2.1.5.5.9.2.2.5.7.1.3]
b. 15 Feb 1898 d. Aft 1984
+
Willie Ann Cline
b. 18 Feb 1863 d. 12 Jan 1931
+
Alice Curtis
b. Abt 1850
9
Susan Wilds
[1.2.1.5.5.9.2.2.6]
b. 16 Mar 1803 d. 18 Jan 1869
8
Susanna Smith
[1.2.1.5.5.9.2.3]
b. 9 Mar 1764 d. 18 Sep 1781
8
Samuel Smith
[1.2.1.5.5.9.2.4]
b. 1 Apr 1766 d. 21 Mar 1811
8
Elizabeth Mary Smith
[1.2.1.5.5.9.2.5]
b. 31 Mar 1768
8
Jacob Smith
[1.2.1.5.5.9.2.6]
b. 24 May 1770
8
Anna Smith
[1.2.1.5.5.9.2.7]
b. 8 Jan 1772
8
Son Smith
[1.2.1.5.5.9.2.8]
b. 13 Apr 1773
8
Benjamin Smith
[1.2.1.5.5.9.2.9]
b. 20 Feb 1776 d. 2 Oct 1778
7
Vashti Smith
[1.2.1.5.5.9.3]
b. 5 Oct 1739 d. Aft 1776
Jacobs Hobbs
b. 16 Jun 1745 d. 20 Jan 1823
8
Jacob Hobbs
[1.2.1.5.5.9.3.1]
b. 21 Feb 1768
8
Abraham Hobbs
[1.2.1.5.5.9.3.2]
b. 16 Dec 1769
8
Samuel Hobbs
[1.2.1.5.5.9.3.3]
b. 21 Feb 1772
8
Vashti Hobbs
[1.2.1.5.5.9.3.4]
b. 2 Feb 1774 d. 14 Feb 1836
8
Abigail Hobbs
[1.2.1.5.5.9.3.5]
b. 10 Aug 1776
Soloman Curtis
b. 10 Jul 1739 d. Apr 1766
8
Solomon Curtis
[1.2.1.5.5.9.3.6]
b. 13 Apr 1766
7
Susannah Smith
[1.2.1.5.5.9.4]
b. 24 Jan 1741 d. 13 May 1766
Isaac Hobbs
b. 20 Apr 1743 d. 3 Jun 1815
8
Sarah Hobbs
[1.2.1.5.5.9.4.1]
b. 16 Nov 1766 d. 27 Jan 1823
8
Susannah Hobbs
[1.2.1.5.5.9.4.2]
b. 16 Nov 1766 d. Abt 1870
8
Priscilla Hobbs
[1.2.1.5.5.9.4.3]
b. 28 May 1769 d. 18 May 1771
8
Isaac Hobbs
[1.2.1.5.5.9.4.4]
b. 19 Aug 1770 d. Abt 1870
8
Elizabeth Hobbs
[1.2.1.5.5.9.4.5]
b. 16 Jan 1773 d. 14 Nov 1850
8
Munson Hobbs
[1.2.1.5.5.9.4.6]
b. 5 Mar 1775 d. Abt 1870
8
Samuel Hobbs
[1.2.1.5.5.9.4.7]
b. 1 Dec 1776 d. Abt 1870
8
Humphrey Hobbs
[1.2.1.5.5.9.4.8]
b. 5 Sep 1779 d. Abt 1870
8
Solomon Hobbs
[1.2.1.5.5.9.4.9]
b. 1782 d. 2 May 1854
7
Asael Smith
[1.2.1.5.5.9.5]
b. 7 Mar 1744 d. 31 Oct 1830
Mary Elizabeth Duty
b. 11 Oct 1743 d. 27 May 1836
8
Jesse Smith
[1.2.1.5.5.9.5.1]
b. 20 Apr 1768 d. 16 Mar 1793
Hannah Peabody
b. 1771 d. 28 Sep 1849
9
Benjamin Peabody Smith
[1.2.1.5.5.9.5.1.1]
b. 2 May 1793 d. 15 Jan 1850
Lois Crandall
b. 3 Nov 1799 d. 10 Mar 1882
10
Esther Ann Smith
[1.2.1.5.5.9.5.1.1.1]
b. 15 Oct 1823 d. 24 Dec 1900
10
Martha Wallace Smith
[1.2.1.5.5.9.5.1.1.2]
b. 14 Oct 1825 d. 22 May 1849
10
Edwin Wallace Smith
[1.2.1.5.5.9.5.1.1.3]
b. 13 Apr 1827 d. 1 Sep 1907
10
Henry Storrs Smith
[1.2.1.5.5.9.5.1.1.4]
b. 11 Mar 1829 d. 3 Dec 1852
10
Benjamin Smith
[1.2.1.5.5.9.5.1.1.5]
b. 28 Apr 1833 d. 28 May 1833
10
Peabody Smith
[1.2.1.5.5.9.5.1.1.6]
b. 28 Apr 1833 d. 28 May 1833
10
Adeline Smith
[1.2.1.5.5.9.5.1.1.7]
b. 6 May 1834 d. 20 Aug 1911
10
James Smith
[1.2.1.5.5.9.5.1.1.8]
b. 16 Mar 1836 d. 21 Jan 1840
10
Jane Smith
[1.2.1.5.5.9.5.1.1.9]
b. 16 Mar 1836 d. 18 May 1917
10
Lois Ann Smith
[1.2.1.5.5.9.5.1.1.10]
b. 6 Apr 1838 d. 10 Aug 1922
10
Adelia Clarissa Smith
[1.2.1.5.5.9.5.1.1.11]
b. 12 Jul 1841 d. 6 Apr 1908
9
Eliza Smith
[1.2.1.5.5.9.5.1.2]
b. 9 Mar 1795 d. 22 Jul 1870
Stoddard Hunt
b. 14 Feb 1780 d. 10 Dec 1855
10
Daniel Smith Hunt
[1.2.1.5.5.9.5.1.2.1]
b. 10 Dec 1826 d. 19 Feb 1882
10
Esther Hunt
[1.2.1.5.5.9.5.1.2.2]
b. 10 Apr 1828 d. 1915
10
Fanny Hunt
[1.2.1.5.5.9.5.1.2.3]
b. 8 Sep 1829 d. 30 May 1852
10
Jesse Hunt
[1.2.1.5.5.9.5.1.2.4]
b. 7 Apr 1831 d. 17 Apr 1871
10
Stephen Hunt
[1.2.1.5.5.9.5.1.2.5]
b. 16 Nov 1833 d. 16 Nov 1922
10
Royal Hunt
[1.2.1.5.5.9.5.1.2.6]
b. 22 May 1836 d. 23 Dec 1880
10
Eliza Hunt
[1.2.1.5.5.9.5.1.2.7]
b. 1 Aug 1840 d. 27 Nov 1918
9
Ira Smith
[1.2.1.5.5.9.5.1.3]
b. 30 Jan 1797 d. 5 Mar 1874
Lucy Post
10
Harry Smith
[1.2.1.5.5.9.5.1.3.1]
b. 26 Jul 1824 d. 4 Apr 1906
10
Norman E. Smith
[1.2.1.5.5.9.5.1.3.2]
b. 24 Nov 1825 d. 19 May 1918
10
James M. Smith
[1.2.1.5.5.9.5.1.3.3]
b. 2 Aug 1827 d. 21 Oct 1902
10
Esther Harmon Smith
[1.2.1.5.5.9.5.1.3.4]
b. 19 Feb 1831 d. 24 Dec 1917
10
Hannah P. Smith
[1.2.1.5.5.9.5.1.3.5]
b. 25 Sep 1832 d. 7 Mar 1859
10
Eliza Smith
[1.2.1.5.5.9.5.1.3.6]
b. 27 Jun 1834 d. 15 Dec 1907
10
Jesse Smith
[1.2.1.5.5.9.5.1.3.7]
b. 30 Dec 1837 d. 31 Dec 1917
9
Harvey Smith
[1.2.1.5.5.9.5.1.4]
b. 1 Apr 1799 d. 20 Feb 1872
Betsey M Yurann
b. 1 Jan 1800 d. 12 Jan 1839
10
Charles Chandler Smith
[1.2.1.5.5.9.5.1.4.1]
b. 13 Feb 1827 d. 14 Feb 1870
10
Horace Buck Smith
[1.2.1.5.5.9.5.1.4.2]
b. 24 Aug 1828 d. 10 Jan 1904
10
Elizabeth Smith
[1.2.1.5.5.9.5.1.4.3]
b. 1829
10
Lucy E. Smith
[1.2.1.5.5.9.5.1.4.4]
b. 7 Apr 1830 d. 4 Apr 1842
10
Betsey M. Smith
[1.2.1.5.5.9.5.1.4.5]
b. 7 May 1832 d. 8 May 1832
10
James Renwick Smith
[1.2.1.5.5.9.5.1.4.6]
b. 5 Sep 1833 d. 4 Apr 1842
10
Jason Smith
[1.2.1.5.5.9.5.1.4.7]
b. 27 Jul 1835 d. 23 Mar 1881
10
William N Smith
[1.2.1.5.5.9.5.1.4.8]
b. 22 Oct 1838 d. 6 May 1911
Electa Jenne
b. 25 Nov 1822 d. 17 Nov 1870
10
Benjamin C
[1.2.1.5.5.9.5.1.4.9]
b. 24 Jul 1854 d. 2 May 1872
10
Jane
[1.2.1.5.5.9.5.1.4.10]
b. 30 Sep 1855 d. 18 Oct 1918
10
Friend Smith
[1.2.1.5.5.9.5.1.4.11]
b. 19 Aug 1858 d. 8 Feb 1936
10
Miranda Smith
[1.2.1.5.5.9.5.1.4.12]
b. 15 Feb 1860 d. 26 May 1934
10
King E. Smith
[1.2.1.5.5.9.5.1.4.13]
b. 19 Mar 1862 d. 12 Jun 1865
9
Harriet Tupper Smith
[1.2.1.5.5.9.5.1.5]
b. 8 Apr 1801 d. Apr 1879
+
Ezra Martindall
9
Stephen Smith
[1.2.1.5.5.9.5.1.6]
b. 2 May 1803 d. 16 Apr 1851
+
Hannah Miller Hunt
b. Abt 1805
9
Mary Polly Smith
[1.2.1.5.5.9.5.1.7]
b. 4 May 1805 d. 13 Jun 1870
+
Hiram Chapman
b. 8 Apr 1795 d. 1867
9
Catherine Smith
[1.2.1.5.5.9.5.1.8]
b. 13 Jul 1807 d. 2 May 1888
James Kelsey
b. 9 Jun 1801 d. 9 Sep 1883
10
Hannah Kelsey
[1.2.1.5.5.9.5.1.8.1]
b. 2 Mar 1829 d. 20 Nov 1905
10
Amanda Kelsey
[1.2.1.5.5.9.5.1.8.2]
b. 24 Oct 1830 d. 1 Jun 1914
10
Eleanor Amelia Kelsey
[1.2.1.5.5.9.5.1.8.3]
b. 5 Jul 1832 d. 9 Sep 1900
10
James Edwin Kelsey
[1.2.1.5.5.9.5.1.8.4]
b. 5 Jul 1832 d. 27 Oct 1910
10
Julius Marcellus Kelsey
[1.2.1.5.5.9.5.1.8.5]
b. 21 Jul 1836 d. 3 Nov 1905
10
Royal Smith Kelsey
[1.2.1.5.5.9.5.1.8.6]
b. 7 Jun 1839 d. 24 Sep 1865
10
Mark Kelsey
[1.2.1.5.5.9.5.1.8.7]
b. 8 Aug 1843 d. 26 Nov 1877
9
Royal Smith
[1.2.1.5.5.9.5.1.9]
b. 2 Jul 1809 d. 1882
+
Happeelona Peck
9
Sarah B Smith
[1.2.1.5.5.9.5.1.10]
b. 16 Dec 1810 d. 2 Oct 1887
+
Henry Barnard
+
Christene Smith
8
Priscilla Smith
[1.2.1.5.5.9.5.2]
b. 21 Oct 1769 d. 17 Apr 1860
John Curtis Waller
9
Calvin C. Waller
[1.2.1.5.5.9.5.2.1]
b. 6 Jun 1797 d. Jun 1864
9
Dolly Waller
[1.2.1.5.5.9.5.2.2]
b. 16 Oct 1799 d. 20 Jun 1800
9
Marshall Waller
[1.2.1.5.5.9.5.2.3]
b. 18 Mar 1801
9
Royal H Waller
[1.2.1.5.5.9.5.2.4]
b. 29 Nov 1802 d. 29 Sep 1866
9
Dudley C Waller
[1.2.1.5.5.9.5.2.5]
b. 29 Sep 1804 d. Abt 1868
+
Mrs Dudley C Waller
b. Abt 1806
9
Bushrod W Waller
[1.2.1.5.5.9.5.2.6]
b. 18 Oct 1806
9
Silas Waller
[1.2.1.5.5.9.5.2.7]
b. 1 Jan 1809 d. 2 Jun 1866
Marietta Smith
b. 1811
10
Francis Waller
[1.2.1.5.5.9.5.2.7.1]
b. 9 Feb 1841 d. 27 Oct 1844
10
Ellen Waller
[1.2.1.5.5.9.5.2.7.2]
b. 11 Sep 1845
10
Anna Buffington
[1.2.1.5.5.9.5.2.7.3]
b. 17 Dec 1848 d. 22 Jan 1852
10
Lilla Waller
[1.2.1.5.5.9.5.2.7.4]
b. 21 Dec 1851 d. 20 Jan 1929
9
Salley P Waller
[1.2.1.5.5.9.5.2.8]
b. 31 Oct 1810 d. 15 Aug 1874
9
John J Waller
[1.2.1.5.5.9.5.2.9]
b. 9 Sep 1812 d. 5 Nov 1812
+
Michael Smith
8
Joseph Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3]
b. 12 Jul 1771 d. 14 Sep 1840
Lucy Mack
b. 8 Jul 1775 d. 14 May 1856
9
Son Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.1]
b. 1797 d. 1797
9
Daughter Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.2]
b. 1797 d. 1797
9
Alvin Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.3]
b. 11 Feb 1798 d. 19 Nov 1823
9
Hyrum Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4]
b. 9 Feb 1800 d. 27 Jun 1844
Jerusha Barden
b. 15 Feb 1805 d. 13 Oct 1837
10
Lovina Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.1]
b. 16 Sep 1827 d. 8 Oct 1876
10
Mary Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.2]
b. 27 Jun 1829 d. 29 May 1832
10
John Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.3]
b. 22 Sep 1832
10
Hyrum Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.4]
b. 27 Apr 1834 d. 21 Sep 1841
10
Jerusha Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.5]
b. 13 Jan 1836 d. 27 Jun 1912
10
Sarah Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.6]
b. 2 Oct 1837 d. 6 Nov 1876
Mary Fielding
b. 21 Jul 1801 d. 21 Sep 1852
10
Joseph Fielding Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7]
b. 13 Nov 1838 d. 19 Nov 1918
+
Levira Annette Clark Smith
b. 29 Apr 1842 d. 18 Dec 1888
Julina Lambson
b. 18 Jun 1849 d. 10 Jan 1936
11
Edward Aurthur Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.1]
b. 1 Nov 1858 d. 17 Jul 1911
11
Mercy Josephine Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.2]
b. 14 Aug 1867 d. 6 Jun 1870
11
Mary Sophronia Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.3]
b. 7 Oct 1869 d. 5 Jan 1948
11
Donnette Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.4]
b. 17 Sep 1872 d. 16 Sep 1961
11
Joseph Fielding Smith, Jr
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.5]
b. 19 Jul 1876 d. 2 Jul 1972
Emily Louie Shurtliff
b. 16 Jun 1876 d. 30 Mar 1908
12
Josephine Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.5.1]
b. 18 Sep 1902 d. 16 Sep 1995
12
Julina Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.5.2]
b. 5 Feb 1906 d. 9 May 1997
Ethel Georgina Reynolds
b. 23 Oct 1889 d. 26 Aug 1937
12
Emily Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.5.3]
b. 9 Aug 1909 d. 21 Aug 1994
12
Naomi Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.5.4]
b. 16 Nov 1910 d. 15 Oct 1979
12
Lois Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.5.5]
b. 26 Mar 1912 d. 23 Jan 1981
12
Joseph Fielding Smith, Jr
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.5.6]
b. 18 Dec 1913 d. 23 Aug 1974
12
Amelia Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.5.7]
b. 21 Jun 1916 d. 22 Sep 2005 [
=>
]
12
Lewis Warren Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.5.8]
b. 10 Mar 1918 d. 12 Dec 1944
12
George Reynolds Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.5.9]
b. 13 Feb 1921 d. 28 Oct 1982
12
Living
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.5.10]
12
Living
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.5.11]
+
Jessie Ella Evans
b. 29 Dec 1902 d. 3 Aug 1971
11
David Asael Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.6]
b. 24 May 1879 bur. 9 Apr 1952
11
George Carlos Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.7]
b. 14 Oct 1881 d. 25 Feb 1931
11
Julina Clarissa Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.8]
b. 10 Feb 1884 d. 1 Aug 1923
11
Elias Wesley Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.9]
b. 21 Apr 1886 d. 28 Dec 1970
11
Emily Jane Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.10]
b. 11 Sep 1888 d. 12 Dec 1982
11
Rachel Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.11]
b. 11 Dec 1890 d. 14 Dec 1986
11
Edith Eleanor Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.12]
b. 3 Jan 1894 d. 21 May 1987
11
Marjorie Virginia Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.13]
b. 7 Dec 1906 d. 17 Nov 1994
Sarah Ellen Richards
b. 25 Aug 1850 d. 22 Mar 1915
11
Sarah Ellen Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.14]
b. 5 Feb 1869 d. 11 Feb 1869
11
Leonora Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.15]
b. 30 Jan 1871 bur. 26 Dec 1907
11
Joseph Richards Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.16]
b. 22 Feb 1873 d. 2 Oct 1954
11
Heber John Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.17]
b. 3 Jul 1876 d. 3 Mar 1877
11
Rhoda Ann Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.18]
b. 20 Jul 1878 d. 6 Jul 1879
11
Minerva Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.19]
b. 30 Apr 1880 d. 24 Jan 1958
11
Alice Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.20]
b. 27 Jul 1882 d. 29 Apr 1901
11
Willard Richards Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.21]
b. 20 Nov 1884 d. 11 Sep 1972
Florence Grant
b. 7 Feb 1883 d. 6 Mar 1977
12
Willard Grant Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.21.1]
b. 12 May 1911 d. 16 Dec 1996
12
Florence Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.21.2]
b. 7 Apr 1913 d. 5 Mar 2017
12
Richards Grant Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.21.3]
b. 10 Mar 1915 d. 6 Mar 2000
12
Briant Grant Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.21.4]
b. 15 Dec 1916 d. 6 Jan 2006
12
Heber Joseph Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.21.5]
b. 23 Dec 1918 d. 26 Nov 1943
12
Howard Grant Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.21.6]
b. 13 Mar 1921 d. 28 May 2010
12
Sarah Ellen Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.21.7]
b. 5 May 1923 d. 23 Oct 1980 [
=>
]
12
Paul Grant Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.21.8]
b. 19 May 1925 d. 21 Jan 2000
11
Franklin Richards Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.22]
b. 12 May 1888 d. 25 Dec 1967
11
Jeanetta Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.23]
b. 25 Aug 1891 d. 27 Jan 1932
11
Asenath Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.24]
b. 28 Dec 1896 d. 3 Aug 1982
Edna Lambson
b. 3 Mar 1851
11
Hyrum Mack Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.25]
b. 21 Mar 1872 d. 23 Jan 1918
11
Alvin Fielding Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.26]
b. 7 Aug 1874 d. 4 Jan 1948
11
Alfred Jason Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.27]
b. 13 Dec 1876 d. 6 Apr 1878
11
Edna Melissa Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.28]
b. 6 Oct 1879 d. 26 Oct 1958
11
Albert Jesse Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.29]
b. 16 Sep 1881 d. 25 Aug 1883
11
Robert Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.30]
b. 12 Nov 1883 d. 4 Feb 1886
11
Emma Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.31]
b. 21 Aug 1888 d. 29 Dec 1969
11
Zina Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.32]
b. 11 Oct 1890 d. 25 Oct 1915
11
Ruth Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.33]
b. 21 Dec 1893 d. 17 Mar 1898
11
Martha Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.34]
b. 12 May 1897 d. 7 Aug 1977
Alice Ann Kimball
b. 6 Sep 1858 d. 19 Dec 1946
11
Alice May Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.35]
b. 11 Oct 1877 d. 20 Oct 1920
11
Heber Chase Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.36]
b. 19 Nov 1881 d. 29 Dec 1971
11
Charles Coulson Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.37]
b. 19 Nov 1881 d. 21 Apr 1933
11
Lucy Mack Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.38]
b. 14 Apr 1890 d. 24 Nov 1933
11
Andrew Kimball Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.39]
b. 6 Jan 1893 d. 23 Aug 1951
11
Jesse Kimball Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.40]
b. 21 May 1896 d. 21 May 1953
11
Fielding Kimball Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.41]
b. 9 Apr 1900 d. 20 Oct 1974
Mary Taylor Schwartz
b. 30 Apr 1865 d. 5 Dec 1956
11
John Schwartz Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.42]
b. 20 Aug 1888 d. 3 Aug 1889
11
Calvin Schwartz Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.43]
b. 29 May 1890
11
Samuel Schwartz Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.44]
b. 26 Oct 1892 d. 10 May 1983
11
James Schwartz Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.45]
b. 13 Nov 1894 d. 6 Nov 1950
11
Agnes Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.46]
b. 3 Nov 1897 d. 9 Mar 1966
11
Silas Schwartz Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.47]
b. 3 Jan 1900 d. 23 Apr 1983
11
Royal Grant Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.48]
b. 21 May 1906 d. 30 May 1971
10
Martha Ann Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.8]
b. 14 May 1841 d. 19 Oct 1923
William Jasper Harris
b. 25 Oct 1836 d. 24 Apr 1909
11
William Jasper Harris, Jr
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.8.1]
b. 4 Aug 1859 d. 23 Aug 1926
11
Joseph Albert Harris
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.8.2]
b. 19 Aug 1861 d. 28 May 1911
11
Hyrum Smith Harris
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.8.3]
b. 15 Aug 1863 d. 24 Feb 1924
11
Mary Emily Harris
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.8.4]
b. 23 Oct 1865 d. 25 Nov 1947
11
Franklin Hill Harris
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.8.5]
b. 11 Sep 1867 d. 5 Feb 1947
11
Lucy Smith Harris
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.8.6]
b. 10 Mar 1870 d. 25 Jul 1903
11
John Fielding Harris
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.8.7]
b. 28 Jun 1872 d. 28 Nov 1946
11
Mercy Ann Harris
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.8.8]
b. 30 Mar 1874 d. 23 Jan 1905
11
Zina Christine Harris
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.8.9]
b. 13 May 1876 d. 16 Mar 1958
11
Martha Artemesia Harris
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.8.10]
b. 27 Jun 1879 d. 12 Aug 1965
11
Sarah Lovina Harris
[1.2.1.5.5.9.5.3.4.8.11]
b. 8 Dec 1882 d. 21 Apr 1961
+
Catherine Phillips
b. 1 Aug 1819 d. 26 Sep 1905
+
Mercy Rachel Fielding
b. 15 Jun 1807 d. 15 Sep 1893
9
Sophronia Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.5]
b. 17 May 1803 d. 28 Oct 1876
Calvin W Stoddard
b. 7 Sep 1801 d. 19 Nov 1836
10
Eunice Stoddard
[1.2.1.5.5.9.5.3.5.1]
b. 22 Mar 1830 d. 24 Jun 1831
10
Mariah Stoddard
[1.2.1.5.5.9.5.3.5.2]
b. 12 Apr 1832 d. 8 Oct 1896
+
William McCleary
b. 9 Oct 1793 d. Jun 1846
9
Samuel Harrison Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.6]
b. 13 Mar 1808 d. 30 Jul 1844
Mary Bailey
b. 20 Dec 1808 d. 25 Jan 1841
10
Susanna Bailey Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.6.1]
b. 27 Oct 1835 d. 14 Dec 1905
10
Mary Bailey Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.6.2]
b. 27 Mar 1837 d. 14 Oct 1916
10
Samuel Harrison Bailey Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.6.3]
b. 1 Aug 1838 d. 12 Jun 1914
10
Lucy Bailey Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.6.4]
b. 6 Jan 1841 d. Jan 1841
Levira Clark
b. 30 Jul 1815 d. 1 Jan 1893
10
Levira Annette Clark Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.6.5]
b. 29 Apr 1842 d. 18 Dec 1888
+
Joseph Fielding Smith
b. 13 Nov 1838 d. 19 Nov 1918
10
Lovisa Clark Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.6.6]
b. 28 Aug 1843 d. Dec 1843
10
Lucy Jane Clark Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.6.7]
b. 20 Aug 1844 d. 1844
9
Ephraim Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.7]
b. 13 Mar 1810 d. 24 Mar 1810
9
William B Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.8]
b. 13 Mar 1811 d. 13 Nov 1893
Carolina Amanda Grant
b. 22 Jan 1814 d. 22 May 1845
10
Mary Jane Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.8.1]
b. 7 Jan 1834 d. 21 Dec 1878
10
Caroline L Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.8.2]
b. Aug 1839 d. 9 Jan 1878
Roxie Ann Grant
b. 16 Mar 1825 d. 30 Mar 1900
10
Thalia Grant Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.8.3]
b. 21 Sep 1848 d. 27 Nov 1924
10
Hyrum Wallace Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.8.4]
b. 17 Aug 1850 d. 27 Jan 1935
Eliza Elise Jane Sanborn
b. 16 Apr 1827 d. 7 Mar 1889
10
William Enoch Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.8.5]
b. 23 Jul 1858 d. 13 Feb 1930
10
Edson Don Carlos Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.8.6]
b. 16 Sep 1862 d. 13 Feb 1939
10
Louise Mae "Loie " Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.8.7]
b. 8 May 1866 d. 10 May 1925
+
Rosella Goyette
b. 16 May 1830 d. 6 Apr 1923
9
Katherine Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.9]
b. 28 Jul 1813 d. 1 Feb 1900
Wilkins Jenkins Salisbury
b. 6 Jan 1809 d. 27 Nov 1853
10
Elizabeth Salisbury
[1.2.1.5.5.9.5.3.9.1]
b. 9 Apr 1832 d. 15 Jul 1832
10
Lucy Salisbury
[1.2.1.5.5.9.5.3.9.2]
b. 3 Oct 1834 d. 18 Oct 1892
10
Reverend Solomon Jenkins Salisbury
[1.2.1.5.5.9.5.3.9.3]
b. 18 Sep 1835 d. 12 Jan 1927
10
Alvin Salisbury
[1.2.1.5.5.9.5.3.9.4]
b. 7 Jun 1838 d. 21 Aug 1880
10
Reverend Don C. Salisbury
[1.2.1.5.5.9.5.3.9.5]
b. 25 Oct 1840 d. 6 Apr 1919
10
Emma C Salisbury
[1.2.1.5.5.9.5.3.9.6]
b. 25 Mar 1844 d. 10 Oct 1846
10
Lorin Ephraim Salisbury
[1.2.1.5.5.9.5.3.9.7]
b. 4 May 1845 d. 18 Nov 1849
10
Frederick Vilian Salisbury
[1.2.1.5.5.9.5.3.9.8]
b. 27 Jan 1850 d. 24 Feb 1934
+
Joseph Younger
b. 1805 d. 1900
9
Don Carlos Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.10]
b. 25 Mar 1816 d. 7 Aug 1841
Agnes Moultin Coolbrith
b. 11 Jul 1811 d. 26 Dec 1876
10
Agnes Charlotte Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.10.1]
b. 7 Aug 1836 d. 31 Jan 1873
10
Sophronia C. Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.10.2]
b. 22 Apr 1838 d. 3 Oct 1843
10
Josephine Donna "Ina Coolbrith" Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.10.3]
b. 10 Mar 1841 d. 29 Feb 1928
Robert Bruce Carsley
b. 6 Jun 1833 d. 14 Aug 1905
11
Son 1 Carsley
[1.2.1.5.5.9.5.3.10.3.1]
b. 1860 d. 1860
11
Son 2 Carsley
[1.2.1.5.5.9.5.3.10.3.2]
b. 1861 d. Bef 1865
9
Lucy Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.11]
b. 18 Jul 1821 d. 9 Dec 1882
Arthur Millikin
b. 9 May 1817 d. 23 Apr 1882
10
Don Carlos Smith Millikin
[1.2.1.5.5.9.5.3.11.1]
b. 13 Oct 1843 d. 26 Nov 1932
10
Sarah M Millikin
[1.2.1.5.5.9.5.3.11.2]
b. 13 Sep 1844 d. 23 Nov 1934
10
George William Dell Millikin
[1.2.1.5.5.9.5.3.11.3]
b. 4 Mar 1848 d. 16 Jan 1913
10
Florence Arabella Millikin
[1.2.1.5.5.9.5.3.11.4]
b. 23 May 1850 d. 21 Oct 1927
10
Julia Amelia Millikin
[1.2.1.5.5.9.5.3.11.5]
b. 17 Jun 1853 d. 7 Jun 1888
10
Frances A. Millikin
[1.2.1.5.5.9.5.3.11.6]
b. 26 Oct 1856 d. 14 Mar 1858
10
Charles Arthur Millikin
[1.2.1.5.5.9.5.3.11.7]
b. 31 Aug 1858 d. 12 May 1884
10
Clara Irene Millikin
[1.2.1.5.5.9.5.3.11.8]
b. 23 Aug 1861 d. 26 Mar 1948
10
Clarence Hyrum Millikin
[1.2.1.5.5.9.5.3.11.9]
b. 26 Mar 1865 d. 5 Apr 1922
9
Joseph Smith, Jr
[1.2.1.5.5.9.5.3.12]
b. 23 Dec 1805 d. 27 Jun 1844
Emma Hale
b. 10 Jul 1804 d. 30 Apr 1879
10
Alvin Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.1]
b. 15 Jun 1828 d. 15 Jun 1828
10
Joseph Murdock Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.2]
b. 30 Apr 1831 d. 29 Mar 1832
10
Julia Murdock Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.3]
b. 30 Apr 1831 d. 12 Sep 1880
+
Elisha Dixon
b. 1827 d. 1850
+
John J Middleton
b. Abt 1827 d. Abt 1869
10
Thaddeus Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.4]
b. 30 Apr 1831 d. 30 Apr 1831
10
Louisa Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.5]
b. 30 Apr 1831 d. 30 Apr 1831
10
Joseph Smith, III
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.6]
b. 6 Nov 1832 d. 10 Dec 1914
Emmeline Griswold
b. 12 Mar 1838 d. 25 Mar 1869
11
Emma Josepha Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.6.1]
b. 28 Jul 1857 d. 30 Nov 1940
Alexander McCallum
b. 4 Apr 1848 d. 8 Oct 1928
12
Joseph Alma McCallum
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.6.1.1]
b. 19 Sep 1878 d. 1967 [
=>
]
12
Arthur Alexander McCallum
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.6.1.2]
b. 2 Jun 1882 d. 27 Mar 1937
12
William James McCallum
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.6.1.3]
b. 1 Aug 1890 d. 10 Oct 1963
12
Oscar MacEo McCallum
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.6.1.4]
b. 12 Jun 1896 d. 20 Feb 1898
11
Evelyn Rebecca Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.6.2]
b. 25 Jan 1859 d. 30 Sep 1859
11
Carrie Lucinda Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.6.3]
b. 15 Sep 1861 d. 27 Apr 1944
Francis Marion Weld
b. 9 Sep 1858 d. 4 Jul 1938
12
Emma Rebecca Weld
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.6.3.1]
b. 3 Jul 1889 d. Abt 1975 [
=>
]
11
Zaide Viola Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.6.4]
b. 25 Apr 1863 d. 8 Jan 1891
Richard Savary Salyards
b. 16 Jun 1857 d. 27 Nov 1944
12
Emma Marie Salyards
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.6.4.1]
b. 8 Aug 1884 d. 16 Sep 1886
12
Zaide Aileen Salyards
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.6.4.2]
b. 11 Jan 1887 d. 27 May 1973
12
Joseph Richard Salyards
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.6.4.3]
b. 18 Aug 1888 [
=>
]
12
Richard Savary Salyards
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.6.4.4]
b. 21 Jun 1890 d. 28 Feb 1988 [
=>
]
11
Joseph Arthur Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.6.5]
b. 12 Aug 1865 d. 12 Mar 1866
Bertha Madison
b. 16 Jul 1843 d. 19 Oct 1896
11
David Carlos Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.6.6]
b. 14 Aug 1870 d. 24 Jan 1886
11
Mary Audentia Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.6.7]
b. 23 Mar 1872 d. 5 May 1963
11
Frederick Madison Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.6.8]
b. 21 Jan 1874 d. 20 Mar 1946
11
Israel Alexander Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.6.9]
b. 2 Feb 1876 d. 14 Jun 1958
11
Kenneth Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.6.10]
b. 6 Oct 1877 d. 6 Oct 1877
11
Bertha Azubah Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.6.11]
b. 15 Oct 1878 d. 14 Oct 1884
11
Hale Washington Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.6.12]
b. 22 Feb 1881 d. 10 Jul 1956
11
Blossom Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.6.13]
b. 1 May 1883 d. 1 May 1883
11
Lucy Yeteve Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.6.14]
b. 11 Dec 1884 d. 4 Aug 1945
Ada Rachel Clark
b. 23 Jul 1871 d. 20 Oct 1915
11
Reginald Archer Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.6.15]
b. 26 Dec 1898 d. 20 Jun 1969
11
William Wallace Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.6.16]
b. 18 Nov 1900 d. 4 Aug 1989
11
Reginald Archer Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.6.17]
b. 8 Jan 1903 d. 28 Sep 1974
10
Frederick Granger Williams Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.7]
b. 20 Jun 1836 d. 13 Apr 1862
Anna Marie Jones
b. 7 Apr 1841 d. 11 Oct 1901
11
Alice Fredericka Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.7.1]
b. 27 Nov 1858 d. 5 Nov 1932
10
Alexander Hale Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8]
b. 2 Jun 1838 d. 12 Aug 1909
Elizabeth Agnes Kendall
b. 16 Jun 1845 d. 7 May 1919
11
Frederick Alexander Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.1]
b. 19 Jan 1862 d. 25 Jun 1954
Mary Angelina Walker
b. 18 Mar 1867 d. 3 Dec 1931
12
Alexander David Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.1.1]
b. 18 Aug 1885 d. 20 Oct 1891
12
Gladys Inez Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.1.2]
b. 17 Dec 1886 d. 17 Jul 1983 [
=>
]
12
Joy May Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.1.3]
b. 13 Jul 1889 d. 29 Jul 1961 [
=>
]
12
Glaud Leslie Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.1.4]
b. 19 Jan 1891 d. 16 Feb 1986 [
=>
]
12
Freda Saloam Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.1.5]
b. 3 Dec 1892 d. 13 Oct 1974
12
Winsome Lavinia Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.1.6]
b. 20 Aug 1896 d. 30 Nov 1986 [
=>
]
12
Frederick Augenstein Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.1.7]
b. 19 Mar 1899 d. Jan 1966
12
Harold Legrand Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.1.8]
b. 12 Jan 1902 d. 19 Jul 1992
+
Margaret Esther Clark
b. 1 Sep 1901 d. 3 Aug 1987
11
Vida Elizabeth Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.2]
b. 16 Jan 1865 d. 3 Jan 1945
Heman Conoman Smith
b. 27 Sep 1850 d. 17 Apr 1919
12
Heman Hale Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.2.1]
b. 28 Apr 1887 d. 11 Mar 1962 [
=>
]
12
Vida Inez Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.2.2]
b. 16 Jan 1889 d. 24 Oct 1964
12
Anna Earlita Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.2.3]
b. 28 Nov 1890 d. 5 Jun 1975 [
=>
]
12
Lois Elizabeth Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.2.4]
b. 3 Nov 1892 d. 27 Mar 1914 [
=>
]
11
Ina Inez Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.3]
b. 22 Nov 1866 d. 18 Aug 1945
Sidney Garden Wright
b. 26 Jul 1869 d. 8 Aug 1936
12
Claud Kendall Wright
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.3.1]
b. 21 Mar 1892 d. 6 Oct 1972 [
=>
]
12
Vida Grace Wright
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.3.2]
b. 22 Apr 1893 d. 11 Jul 1970 [
=>
]
12
Leland Eric Wright
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.3.3]
b. 30 Dec 1895 d. 11 Nov 1977 [
=>
]
12
Mavis Myra Wright
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.3.4]
b. 30 Dec 1897 d. 15 Aug 1960 [
=>
]
12
Warren Alford Wright
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.3.5]
b. 28 Mar 1899 d. 26 Feb 1980 [
=>
]
12
Edgar Milton Wright
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.3.6]
b. 1 May 1901 d. 2 May 1961 [
=>
]
12
Glory Carmen Wright
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.3.7]
b. 14 Aug 1903 d. 4 Nov 1968
12
Byron Granville Wright
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.3.8]
b. 19 Feb 1906 d. 3 Nov 1974 [
=>
]
12
Marian Inez Wright
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.3.9]
b. 17 Nov 1907 d. 28 Jul 1987 [
=>
]
12
Gwen Hero Wright
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.3.10]
b. 23 Oct 1909 d. 28 Jul 1987
11
Emma Belle Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.4]
b. 17 Mar 1869 d. 3 May 1960
William Forrester Kennedy
b. 5 Jun 1863 d. 22 Mar 1938
12
Arthur Frederick Kennedy
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.4.1]
b. 25 May 1889 d. 1 Jul 1889
12
Joseph Douglas Kennedy
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.4.2]
b. 14 Oct 1891 d. 14 Oct 1891
12
Cecile Grace Kennedy
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.4.3]
b. 3 Jun 1894 d. 9 May 1895
12
Roger Alexander Kennedy
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.4.4]
b. 5 Nov 1897 d. 15 Dec 1933 [
=>
]
12
Glenna Marie Kennedy
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.4.5]
b. 3 Nov 1900 d. 30 Jul 1986
11
Don Alvin Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.5]
b. 17 May 1871 d. 8 Sep 1904
Susan Zeanette Pearsall
b. 21 Apr 1873 d. 22 Jun 1957
12
Velora Belle Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.5.1]
b. 13 Dec 1893 d. 28 Dec 1993
12
Carlos McAllister Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.5.2]
b. 22 May 1895 d. Nov 1981 [
=>
]
12
Beatrice Adelle Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.5.3]
b. 19 Aug 1896 d. 21 Jun 1989 [
=>
]
12
LaJune Harriet Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.5.4]
b. 1 Jul 1899 d. 9 Aug 1985
12
Don Marion Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.5.5]
b. 28 Oct 1901 d. 13 Nov 1983 [
=>
]
12
Maxwell Alexis Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.5.6]
b. 13 Apr 1903 d. 17 Feb 1961 [
=>
]
11
Eva Grace Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.6]
b. 1 Mar 1874 d. 26 Mar 1893
Forrest Lamont Madison
b. 1872 d. 18 Mar 1945
12
Lamont Kendall Madison
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.6.1]
b. 17 Mar 1893 d. 3 Apr 1963 [
=>
]
11
Joseph George Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.7]
b. 7 May 1877 d. 27 Dec 1936
Nellie May Daudelin
b. 19 Jun 1879 d. 2 Apr 1935
12
Josephine Alexandria Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.7.1]
b. 20 Nov 1904 d. 6 Aug 1985 [
=>
]
12
Paul Daudelin Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.7.2]
b. 1 Mar 1908 d. Sep 1975
11
Arthur Marion Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.8]
b. 8 Feb 1880 d. 21 Mar 1964
Estella Almira Danielson
b. 7 Mar 1884 d. 23 Jun 1916
12
Verl Marion Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.8.1]
b. 21 Apr 1905 d. 3 Aug 1980
12
Carl K Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.8.2]
b. 5 Mar 1907 d. 1966
12
Alexander Martin Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.8.3]
b. 7 Feb 1909 d. 30 Sep 1982 [
=>
]
12
Kenneth Julian Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.8.4]
b. 7 Mar 1911 d. 16 Jun 1988 [
=>
]
12
Arthur Granger Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.8.5]
b. 18 Mar 1916 d. 17 Mar 2012
Minnie Catherine Smith
b. 20 May 1894 d. 30 Jan 1988
12
Georgia May Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.8.6]
b. 22 Feb 1923 d. Jul 2009 [
=>
]
12
Myrle Lee Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.8.7]
b. 14 Sep 1925 d. 21 Nov 1985
11
Coral Cecil Rebekah Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.9]
b. 29 Oct 1882 d. 17 Aug 1968
Louis Hurst Horner
b. 21 Sep 1878 d. 18 Feb 1970
12
Louis Brainard Horner
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.9.1]
b. 26 Oct 1906 d. 13 Aug 1980
12
Elizabeth Grace Horner
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.9.2]
b. 16 Apr 1910 d. 19 Jul 1991 [
=>
]
12
James Brandon Horner
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.9.3]
b. 5 Jul 1912 d. 23 Jan 1975
12
Ina Lorena Horner
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.9.4]
b. 30 Aug 1915 d. 1 Dec 2004 [
=>
]
10
Don Carlos Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.9]
b. 13 Jun 1840 d. 15 Sep 1841
10
Thomas Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.10]
b. 6 Feb 1842 d. 6 Feb 1842
10
David Hyrum Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.11]
b. 17 Nov 1844 d. 29 Aug 1904
Clara Charlotte Hartshorn
b. 18 May 1851 d. 9 Aug 1926
11
Elbert Aoriul Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.11.1]
b. 8 Mar 1871 d. 15 May 1959
Clara Abigale Cochran
b. 12 Jan 1874 d. 30 Oct 1948
12
Lawrence David Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.11.1.1]
b. 3 Jun 1896 d. 17 Jun 1896
12
Ronald Gibson Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.11.1.2]
b. 10 Oct 1902 d. 4 Feb 1988
12
Lynn Elbert Smith
[1.2.1.5.5.9.5.3.12.11.1.3]
b. 20 Jan 1911 d. 1 Jun 1992 [
=>
]
+
Agnes Moultin Coolbrith
b. 11 Jul 1811 d. 26 Dec 1876
+
Fanny Young
b. 8 Nov 1787 d. 11 Jun 1859
+
Eliza Roxey Snow
b. 21 Jan 1804 d. 5 Dec 1887
+
Francis Ward "Fanny" Alger
b. 30 Sep 1817 d. 29 Nov 1889
+
Louisa Beaman
b. 7 Feb 1815 d. 15 May 1850
+
Helen Mar Kimball
b. 25 Aug 1828 bur. 15 Nov 1896
+
Emily Dow Partridge
b. 28 Feb 1824 d. 9 Dec 1899
+
Olive Grey Frost
b. 24 Jul 1816 d. 8 Oct 1845
+
Rhoda Richards
b. 8 Aug 1784 d. 17 Jan 1879
+
Lucy Walker
b. 30 Apr 1826 d. 1 Oct 1910
+
Sarah Ann Whitney
b. 22 Mar 1825 d. 4 Sep 1873
+
Prescinda Lothrop Huntington
b. 7 Sep 1810 d. 1 Feb 1892
+
Eliza Partridge
b. 20 Apr 1820 bur. 2 Mar 1886
+
Desdemona Wadsworth Fullmer
b. 6 Oct 1809 d. 9 Feb 1886
+
Zina Diantha Huntington
b. 31 Jan 1821 d. 28 Aug 1901
+
Mary Elizabeth Rollins
b. 9 Apr 1818 d. 17 Dec 1913
+
Martha McBride
b. 17 Mar 1805 d. 20 Nov 1901
+
Sylvia Porter Sessions
b. 31 Jul 1818 d. 12 Apr 1882
+
Patty Bartlett
b. 4 Feb 1795 d. 14 Dec 1892
+
Maria Lawrence
b. 18 Dec 1823 d. 1847
+
Sarah A Lawrence
b. 13 May 1826 d. 28 Nov 1872
8
Asahel Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4]
b. 21 May 1773 d. 21 Jul 1848
Elizabeth Shellenger
b. 1 Dec 1785 d. 14 Oct 1846
9
Elias Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.1]
b. 6 Sep 1804 d. 24 Jun 1888
Amy Jane King
b. 2 Oct 1836 d. 8 Nov 1913
10
Silas Thomas Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.1.1]
b. 4 May 1857 d. 1 May 1945
10
Jesse Moroni Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.1.2]
b. 21 Nov 1858 d. 14 Mar 1937
+
Sarah Ann Smith
b. 11 Jul 1868 d. 2 Feb 1900
10
Rebecca Jane Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.1.3]
b. 23 Sep 1860 d. 18 Jul 1923
10
Mary Alzina Knapp Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.1.4]
b. 16 May 1865 d. 20 Jan 1953
10
Martha Priscilla Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.1.5]
b. 30 May 1865 d. 18 Apr 1946
10
Amy Esther Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.1.6]
b. 11 Aug 1867 d. 21 Sep 1910
10
Angelina Adelia Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.1.7]
b. 11 Jul 1869 d. 8 Mar 1950
10
Franklin Elias Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.1.8]
b. 13 Dec 1871 d. 24 Jul 1917
10
Sarah Susannah Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.1.9]
b. 26 Mar 1873 d. 25 Apr 1952
10
Hiram Bennett Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.1.10]
b. 2 Feb 1877 d. 29 Mar 1951
Lucy Brown
b. 4 Jan 1821 d. 3 Apr 1896
10
Emily Jane Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.1.11]
b. 28 Oct 1850 d. 8 May 1878
Wilford Woodruff, Jr
b. 22 Mar 1840 d. 6 May 1921
11
Lucy Emily Woodruff
[1.2.1.5.5.9.5.4.1.11.1]
b. 10 Jan 1869 d. 5 Nov 1937
George Albert Smith
b. 4 Apr 1870 d. 4 Apr 1951
12
Emily Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.1.11.1.1]
b. 20 Nov 1895 d. 28 Feb 1973
12
Edith Elliott
[1.2.1.5.5.9.5.4.1.11.1.2]
b. 10 Nov 1899 d. 13 Jun 1977
12
George Albert Smith, Jr
[1.2.1.5.5.9.5.4.1.11.1.3]
b. 10 Sep 1905 d. 11 Oct 1969
11
Wilford Smith Woodruff
[1.2.1.5.5.9.5.4.1.11.2]
b. 25 Sep 1871 d. 26 Nov 1955
11
Elias Smith Woodruff
[1.2.1.5.5.9.5.4.1.11.3]
b. 15 Dec 1873 d. 16 Nov 1941
Nellie Maria Davis
b. 5 Mar 1872 d. 14 Oct 1960
12
Nettie Woodruff
[1.2.1.5.5.9.5.4.1.11.3.1]
b. 3 Nov 1902 d. 24 Jun 1988
12
Asahel Davis Woodruff
[1.2.1.5.5.9.5.4.1.11.3.2]
b. 21 Oct 1904 d. 20 Jan 1994 [
=>
]
12
Margaret Woodruff
[1.2.1.5.5.9.5.4.1.11.3.3]
b. 30 Sep 1906 d. 6 Mar 1984
12
Elias Laurence Woodruff
[1.2.1.5.5.9.5.4.1.11.3.4]
b. 26 Apr 1908 d. 28 Aug 1909
12
Mildred Jennie Woodruff
[1.2.1.5.5.9.5.4.1.11.3.5]
b. 28 May 1912 d. 6 Mar 1974
11
Asahel Smith Woodruff
[1.2.1.5.5.9.5.4.1.11.4]
b. 30 Mar 1876 d. 7 Oct 1887
10
Lucy Elizabeth Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.1.12]
b. 24 Jan 1855 d. 3 Jun 1944
10
Elias Asahel Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.1.13]
b. 31 Mar 1857 d. 6 Dec 1942
10
Edith Ann Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.1.14]
b. 5 Aug 1861 d. 27 Jun 1954
9
Emily Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.2]
b. 1 Sep 1806 d. 11 Aug 1893
Samuel Pierce Hoyt
b. 21 Nov 1807 d. 12 Aug 1889
10
Cynthia Ann Hoyt
[1.2.1.5.5.9.5.4.2.1]
b. Abt 1848
10
Hyrum Hoyt
[1.2.1.5.5.9.5.4.2.2]
b. 1855
9
Jessie Johnson Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.3]
b. 6 Oct 1808 d. 1 Jul 1834
Sarah Ann Bennett
b. Abt 1808
10
Priscilla Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.3.1]
c. 26 Jul 1840
9
Esther Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.4]
b. 20 Sep 1810 d. 31 Oct 1856
Amos Botsford Fuller
b. 26 Mar 1810 d. 29 Mar 1853
10
Son Fuller
[1.2.1.5.5.9.5.4.4.1]
b. 15 May 1833 d. 15 May 1833
10
Daughter Fuller
[1.2.1.5.5.9.5.4.4.2]
b. 3 Apr 1834 d. 8 Apr 1834
10
Jesse Johnson Fuller
[1.2.1.5.5.9.5.4.4.3]
b. 1 Jun 1835 d. 31 May 1906
10
Mary Adelia Fuller
[1.2.1.5.5.9.5.4.4.4]
b. 31 Aug 1838 d. 5 Jan 1916
10
Luburn Livonia Fuller
[1.2.1.5.5.9.5.4.4.5]
b. 19 Dec 1840 d. 30 Oct 1887
10
Sophina Alcesta Fuller
[1.2.1.5.5.9.5.4.4.6]
b. 5 May 1843 d. 26 Dec 1930
George Washington Gee, Jr
b. 9 Oct 1841 d. 17 Sep 1919
11
George Washington Gee, III
[1.2.1.5.5.9.5.4.4.6.1]
b. 8 May 1864 d. 26 Mar 1865
11
Elias Amos Gee
[1.2.1.5.5.9.5.4.4.6.2]
b. 29 Jun 1868 d. 27 Apr 1936
11
Georgiana Gee
[1.2.1.5.5.9.5.4.4.6.3]
b. 15 Dec 1869 d. 5 Feb 1899
11
Mary Jane Gee
[1.2.1.5.5.9.5.4.4.6.4]
b. 8 Oct 1871 d. 16 May 1916
11
Esther Gee
[1.2.1.5.5.9.5.4.4.6.5]
b. 29 Oct 1875 d. 22 May 1942
11
Sophina Alcesta Gee
[1.2.1.5.5.9.5.4.4.6.6]
b. 6 Aug 1876 d. 17 May 1959
Joshua Robert Hodson
b. 30 Oct 1874 d. 20 Feb 1947
12
Ethelyn Hodson
[1.2.1.5.5.9.5.4.4.6.6.1]
b. 5 Apr 1903 d. 31 May 1999
12
Marva Hodson
[1.2.1.5.5.9.5.4.4.6.6.2]
b. 6 Nov 1905 d. 17 Dec 1992
12
Waldo Gee Hodson
[1.2.1.5.5.9.5.4.4.6.6.3]
b. 12 Jan 1910 d. 1 Apr 2002
12
Afton Hodson
[1.2.1.5.5.9.5.4.4.6.6.4]
b. 2 Jun 1914 d. 3 Dec 1940
12
Robert Gee Hodson
[1.2.1.5.5.9.5.4.4.6.6.5]
b. 6 Dec 1918 d. 2 Mar 1945
11
Don Carlos Gee
[1.2.1.5.5.9.5.4.4.6.7]
b. 20 Apr 1878 d. 11 Jan 1949
11
Bertha Victoria Gee
[1.2.1.5.5.9.5.4.4.6.8]
b. 31 May 1880 d. 27 Dec 1930
11
Martha Electa Gee
[1.2.1.5.5.9.5.4.4.6.9]
b. 28 Apr 1883 d. 13 May 1968
11
Adelia May Gee
[1.2.1.5.5.9.5.4.4.6.10]
b. 14 May 1885 d. 17 Feb 1964
10
Amos Botsford Fuller
[1.2.1.5.5.9.5.4.4.7]
b. 28 Sep 1846 d. 18 Aug 1879
10
Esther Victoria Fuller
[1.2.1.5.5.9.5.4.4.8]
b. 13 Jan 1848 d. 4 Sep 1857
9
Mary Jane Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.5]
b. 29 Apr 1815 d. 1 Mar 1878
George Washington Gee
b. 13 Aug 1815 d. 20 Jan 1842
10
Elias Smith Gee
[1.2.1.5.5.9.5.4.5.1]
b. 30 May 1838 d. 10 Aug 1855
10
George Washington Gee, Jr
[1.2.1.5.5.9.5.4.5.2]
b. 9 Oct 1841 d. 17 Sep 1919
Sophina Alcesta Fuller
b. 5 May 1843 d. 26 Dec 1930
11
George Washington Gee, III
[1.2.1.5.5.9.5.4.5.2.1]
b. 8 May 1864 d. 26 Mar 1865
11
Elias Amos Gee
[1.2.1.5.5.9.5.4.5.2.2]
b. 29 Jun 1868 d. 27 Apr 1936
11
Georgiana Gee
[1.2.1.5.5.9.5.4.5.2.3]
b. 15 Dec 1869 d. 5 Feb 1899
11
Mary Jane Gee
[1.2.1.5.5.9.5.4.5.2.4]
b. 8 Oct 1871 d. 16 May 1916
11
Esther Gee
[1.2.1.5.5.9.5.4.5.2.5]
b. 29 Oct 1875 d. 22 May 1942
11
Sophina Alcesta Gee
[1.2.1.5.5.9.5.4.5.2.6]
b. 6 Aug 1876 d. 17 May 1959
Joshua Robert Hodson
b. 30 Oct 1874 d. 20 Feb 1947
12
Ethelyn Hodson
[1.2.1.5.5.9.5.4.5.2.6.1]
b. 5 Apr 1903 d. 31 May 1999
12
Marva Hodson
[1.2.1.5.5.9.5.4.5.2.6.2]
b. 6 Nov 1905 d. 17 Dec 1992
12
Waldo Gee Hodson
[1.2.1.5.5.9.5.4.5.2.6.3]
b. 12 Jan 1910 d. 1 Apr 2002
12
Afton Hodson
[1.2.1.5.5.9.5.4.5.2.6.4]
b. 2 Jun 1914 d. 3 Dec 1940
12
Robert Gee Hodson
[1.2.1.5.5.9.5.4.5.2.6.5]
b. 6 Dec 1918 d. 2 Mar 1945
11
Don Carlos Gee
[1.2.1.5.5.9.5.4.5.2.7]
b. 20 Apr 1878 d. 11 Jan 1949
11
Bertha Victoria Gee
[1.2.1.5.5.9.5.4.5.2.8]
b. 31 May 1880 d. 27 Dec 1930
11
Martha Electa Gee
[1.2.1.5.5.9.5.4.5.2.9]
b. 28 Apr 1883 d. 13 May 1968
11
Adelia May Gee
[1.2.1.5.5.9.5.4.5.2.10]
b. 14 May 1885 d. 17 Feb 1964
9
Julia Priscilla Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.6]
b. 4 Mar 1815 d. 14 Aug 1906
Moses Martin
b. 1 Jun 1812 d. 5 May 1899
10
Julia Priscilla Martin
[1.2.1.5.5.9.5.4.6.1]
b. 1 Aug 1838 d. 14 Jan 1873
10
Napoleon J Martin
[1.2.1.5.5.9.5.4.6.2]
b. 1841
10
Rosella A Martin
[1.2.1.5.5.9.5.4.6.3]
b. 18 Aug 1844 d. 13 Sep 1909
10
Hiram Martin
[1.2.1.5.5.9.5.4.6.4]
b. 1 Aug 1847 d. Sep 1882
10
Joseph Martin
[1.2.1.5.5.9.5.4.6.5]
b. Abt 1850
10
Emma Cecelia Martin
[1.2.1.5.5.9.5.4.6.6]
b. Aug 1850 d. Jul 1882
10
Ada Martin
[1.2.1.5.5.9.5.4.6.7]
b. 1854
9
Silas Schellinger Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.7]
b. 6 Jun 1822 d. 11 Jun 1892
Elizabeth Orton
b. 1 Jun 1826 d. 27 Nov 1902
10
Silas Marion Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.7.1]
b. 17 Apr 1845 d. 20 Oct 1898
10
Julia Elizabeth Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.7.2]
b. 29 Jul 1848 d. 28 Oct 1878
Melvin Ross
b. 24 Sep 1842 d. 29 Nov 1920
11
Sarah Lovina Ross
[1.2.1.5.5.9.5.4.7.2.1]
b. 27 Mar 1863 d. 10 Jan 1919
11
Francis Marion Ross
[1.2.1.5.5.9.5.4.7.2.2]
b. 18 Apr 1866 d. 28 Mar 1949
11
Don Carlos Ross
[1.2.1.5.5.9.5.4.7.2.3]
b. 18 Jul 1867 d. 27 Oct 1918
11
James Melvin Ross
[1.2.1.5.5.9.5.4.7.2.4]
b. 16 Jan 1871 d. 25 Jul 1937
11
Mary Esther Ross
[1.2.1.5.5.9.5.4.7.2.5]
b. 14 Mar 1873 d. 2 Apr 1950
Hyrum Wild Stott
b. 27 Jun 1875 d. 19 Jan 1958
12
Leland Hyrum Stott
[1.2.1.5.5.9.5.4.7.2.5.1]
b. 17 Feb 1897 d. 28 Nov 1981
12
Roscoe Wild Stott
[1.2.1.5.5.9.5.4.7.2.5.2]
b. 28 Jul 1899 d. 26 May 1964
12
Asael R Stott
[1.2.1.5.5.9.5.4.7.2.5.3]
b. 23 Mar 1903 d. 21 Jun 1994
12
Percy Lynn Stott
[1.2.1.5.5.9.5.4.7.2.5.4]
b. 4 Dec 1920 d. 16 Nov 1995 [
=>
]
11
Silas Asahel Ross
[1.2.1.5.5.9.5.4.7.2.6]
b. 17 Jun 1875 d. 1895
11
Emma Ross
[1.2.1.5.5.9.5.4.7.2.7]
b. 7 Mar 1878 d. 1881
10
Frederick Asael Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.7.3]
b. 24 Jan 1850 d. 1850
10
Mary Jane Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.7.4]
b. 17 Jun 1853 d. 5 Jan 1917
John Thompson Rowley
b. 7 Nov 1847 d. 31 Jan 1925
11
John Henry Rowley
[1.2.1.5.5.9.5.4.7.4.1]
b. 10 Feb 1882 d. 14 Aug 1928
11
David Smith Rowley
[1.2.1.5.5.9.5.4.7.4.2]
b. 29 Aug 1883 d. 26 Jan 1955
11
Silas Rowley
[1.2.1.5.5.9.5.4.7.4.3]
b. 28 Oct 1885 d. 11 Oct 1949
11
Mary Ann Rowley
[1.2.1.5.5.9.5.4.7.4.4]
b. 5 Dec 1887 d. 20 Jul 1968
11
Franklin Irvin Rowley
[1.2.1.5.5.9.5.4.7.4.5]
b. 1 Jan 1890 d. 18 Jun 1951
11
Ephraim Rowley
[1.2.1.5.5.9.5.4.7.4.6]
b. 14 Oct 1893 bur. 14 Oct 1893
11
George Albert Rowley
[1.2.1.5.5.9.5.4.7.4.7]
b. 27 Nov 1894 d. 20 Jul 1976
10
Prince Henry Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.7.5]
b. 20 Oct 1858 d. 28 Nov 1922
10
Franklin D Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.7.6]
b. 29 Dec 1862 d. 16 Nov 1924
10
Vienna Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.7.7]
b. 16 Jun 1864 d. 17 Aug 1874
10
Martha Eliza Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.7.8]
b. 8 Oct 1869 d. 19 Jul 1956
Sarah Orton
b. 12 May 1830 d. 11 Dec 1912
10
Prince William Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.7.9]
b. 2 Aug 1859 d. 16 Nov 1909
10
Alexander Randolph Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.7.10]
b. 23 Dec 1861 d. 10 Sep 1865
10
David Hyrum Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.7.11]
b. 23 Dec 1863 d. 11 Mar 1865
10
Elias Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.7.12]
b. 16 May 1867 d. 18 Sep 1942
10
Sarah Esther Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.7.13]
b. 4 Nov 1869 d. 7 Nov 1869
10
Alonzo Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.7.14]
b. 5 Apr 1871 d. 24 Jan 1916
Ova Elizabeth Collins
b. 8 Aug 1879 d. 3 Jun 1960
11
Sarah Ethel Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.7.14.1]
b. 22 May 1901 d. 8 Mar 1997
+
William Edgar Johnson
b. 1897
+
Robert Neil Gladding
b. 14 Mar 1911 d. 21 Nov 1985
11
Rachel Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.7.14.2]
b. 25 Aug 1902 d. 12 May 1964
Russell John Quimby
b. 17 Apr 1892 d. 30 Apr 1979
12
Robbie Bobbie Russell Quimby
[1.2.1.5.5.9.5.4.7.14.2.1]
b. 4 Sep 1920 d. 25 Oct 1988
12
Melvin Jim Quimby
[1.2.1.5.5.9.5.4.7.14.2.2]
b. 10 Jan 1925 d. 3 Sep 2002
11
Fred Alonzo Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.7.14.3]
b. 13 Dec 1903 d. 1 Sep 1929
11
Lawrence Owen Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.7.14.4]
b. 19 Sep 1905 d. 21 Feb 1988
+
Martha Paget
b. 4 Oct 1918 d. 8 Mar 1999
11
Edith Elizabeth Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.7.14.5]
b. 25 Jan 1907 d. 31 Oct 1939
Jack Elmo Crampton
b. 6 May 1910 d. 25 Jun 1991
12
Peggy Lee Crampton
[1.2.1.5.5.9.5.4.7.14.5.1]
b. 6 Jul 1932 d. 30 Aug 2008
11
Arnold Elias Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.7.14.6]
b. 31 Oct 1910 d. 23 Jan 1976
Lavina Paget
b. 16 Apr 1916 d. 12 Feb 2013
12
Diane Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.7.14.6.1]
b. 29 Aug 1939 d. 12 Sep 1939
11
Grace Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.7.14.7]
b. 23 Feb 1913 d. 23 Nov 1997
Gordon Phillips Fraser
b. 6 Jun 1909 d. 9 Dec 1956
12
Gerald Gary Fraser
[1.2.1.5.5.9.5.4.7.14.7.1]
b. 30 Mar 1936 d. 11 Jan 2006
12
Daniel William Fraser
[1.2.1.5.5.9.5.4.7.14.7.2]
b. 13 Jul 1938 d. 19 Sep 1987
9
Martha Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.8]
b. 9 Jun 1817 d. 12 Oct 1902
Hiram Bell Bennett
b. 1 Mar 1823 d. 17 Aug 1912
10
Henry Bell Bennett
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.1]
b. Jun 1846 d. Jun 1846
10
Hyrum William Asahel Bennett
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.2]
b. 22 Nov 1848 d. 9 Jan 1849
10
Martha Eliza Bennett
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.3]
b. 24 Jan 1849 d. 6 May 1924
Silas Sanford Smith, Jr
b. 26 Oct 1830 d. 11 Oct 1910
11
Sarah Ann Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.1]
b. 11 Jul 1868 d. 2 Feb 1900
+
Jesse Moroni Smith
b. 21 Nov 1858 d. 14 Mar 1937
+
John Cranmer Dalton
b. 9 Jan 1857 d. 31 Aug 1906
11
Martha Eliza Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.2]
b. 17 Mar 1870 d. 7 Jan 1957
Thales Hastings Haskell, Jr
b. 20 Oct 1868 d. 23 Apr 1952
12
Green Dwight Haskell
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.2.1]
b. 8 Dec 1899 d. 25 Apr 1975 [
=>
]
12
Mark Smith Haskell
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.2.2]
b. 21 Apr 1901 d. 21 Feb 1958
12
Annie Haskell
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.2.3]
b. 10 Sep 1902 d. 11 Feb 1993 [
=>
]
12
Thales Edward Haskell
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.2.4]
b. 14 Oct 1904 d. 22 Dec 1982 [
=>
]
12
Hattie Haskell
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.2.5]
b. 3 Oct 1907 d. 1 Jan 1963
11
Curtis Bennett Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.3]
b. 23 Oct 1871 d. 28 Nov 1942
+
Ursula Pearl Harrison
b. 25 Jul 1879 d. 10 Nov 1960
11
Elias Austin Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.4]
b. 4 Mar 1874 d. 27 Jun 1925
Jessie Arlettia Block
b. 20 Feb 1879 d. 22 Apr 1958
12
Eva Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.4.1]
b. 8 Jun 1899 d. 22 Aug 1979 [
=>
]
12
Austin Block Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.4.2]
b. 26 Dec 1900 d. 1 Aug 1976 [
=>
]
12
Elias Penn Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.4.3]
b. 1 Oct 1902 d. 1 Feb 1976
12
Mack Bennett Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.4.4]
b. 23 Nov 1905 d. 1975 [
=>
]
12
Rex Poulson Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.4.5]
b. 3 Nov 1910 d. 22 Mar 1925
12
Amy Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.4.6]
b. 26 Sep 1913 d. 20 Mar 1994 [
=>
]
11
Emma Jane Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.5]
b. 4 Apr 1876 d. 16 Jan 1951
Edwin Cleveland Dibble
b. 1 Sep 1869 d. 28 Jan 1947
12
Edwin Smith Dibble
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.5.1]
b. 5 Dec 1901 d. 12 Sep 2003
12
George Smith Dibble
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.5.2]
b. 29 Mar 1904 d. 1 Jun 1992
12
Joseph Smith Dibble
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.5.3]
b. 6 Jun 1907 d. 17 Sep 1973 [
=>
]
12
Asael Smith Dibble
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.5.4]
b. 31 Jul 1910 d. 16 Dec 2000 [
=>
]
12
Verlie Dibble
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.5.5]
b. 25 Nov 1917 d. 19 Sep 1985
11
George Essex Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.6]
b. 24 Sep 1878 d. 26 May 1949
Vista May Rogers
b. 27 Aug 1880 d. 27 Jun 1954
12
May Rhue Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.6.1]
b. 8 Nov 1902 d. 6 Jul 1989
12
George Essex Smith, Jr
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.6.2]
b. 5 Aug 1904 d. 20 Jan 1985
12
Margaret Eliza Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.6.3]
b. 17 May 1906 d. 6 May 1996
12
Silas Bennett Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.6.4]
b. 16 Jan 1908 d. 27 Jan 1908
12
Sanford Snow Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.6.5]
b. 20 Feb 1911 d. 6 Dec 1928
12
Martha Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.6.6]
b. 20 Aug 1915 d. 21 Nov 1915
12
Milton Ralph Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.6.7]
b. 26 Oct 1918 d. 13 Aug 1986
11
Erastus Snow Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.7]
b. 18 Aug 1881 d. 16 Sep 1890
11
Hyrum Asahel Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.8]
b. 15 Sep 1883 d. 16 Jul 1941
Rebecca Pearl Hodson
b. 26 Oct 1883 d. 17 Oct 1965
12
Inez Myrtle Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.8.1]
b. 17 Nov 1905 d. 1 Aug 1994
12
Asahel Earl Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.8.2]
b. 29 Mar 1910 d. 3 Jan 1969 [
=>
]
12
Annie Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.8.3]
b. 24 Nov 1912 d. 23 Feb 1913
12
Fay Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.8.4]
b. 18 Feb 1915 d. 9 Jan 2000
12
Donald Hodson Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.8.5]
b. 19 May 1923 d. 12 Aug 1943
11
Lucy Edith Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.9]
b. 12 Aug 1886 d. 6 Jan 1963
David DuBois Dibble
b. 13 Sep 1876 d. 24 Apr 1975
12
Frances Dibble
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.9.1]
b. 18 Dec 1923 d. 16 Sep 1990 [
=>
]
12
David Smith Dibble
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.9.2]
b. 2 Apr 1928 d. 27 Dec 1993 [
=>
]
11
Joseph Frances Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.10]
b. 7 Apr 1889 d. 14 Feb 1920
Lavinia Ann Webster
b. 2 Mar 1890 d. 29 Nov 1962
12
Verlie W Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.10.1]
b. 14 Oct 1915 d. 17 Feb 2001 [
=>
]
12
Francis Bennett Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.10.2]
b. 29 Oct 1917 d. 12 Apr 1978
12
Arthur Agle Millecan
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.10.3]
b. 30 Jul 1922 d. 10 Apr 2003 [
=>
]
11
Clara Estella Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.11]
b. 4 Aug 1891 d. 10 May 1992
11
Verlie Dorcas Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.12]
b. 14 Oct 1894 d. 23 Dec 1894
10
Ezra Melanthorn Bennett
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.4]
b. 20 Oct 1851 d. 25 Aug 1852
10
Emily Jane Bennett
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.5]
b. 17 Jan 1854 d. 4 May 1903
John Aikens Smith
b. 19 Mar 1854 d. 9 Jan 1923
11
Emily Jane Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.5.1]
b. 5 May 1878 d. 21 Feb 1958
Levi Dunn
b. 9 Jan 1880 d. 9 Feb 1968
12
Emily Dunn
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.5.1.1]
b. 27 Mar 1911 d. 15 Jan 1988 [
=>
]
12
Alton Smith Dunn
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.5.1.2]
b. 19 Feb 1914 d. 6 Oct 1976
12
Leon Bennett Dunn
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.5.1.3]
b. 15 May 1916 d. 17 Feb 1975
12
Marcel Harmon Dunn
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.5.1.4]
b. 12 Jan 1919 d. 24 Aug 2002
11
Sarah Ann Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.5.2]
b. 23 Apr 1883 d. 22 Feb 1969
Joseph Beharm DePriest
b. 27 Jan 1881 d. 15 May 1969
12
Emily Lenella DePriest
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.5.2.1]
b. 22 Oct 1909 d. 17 Nov 1990
12
Lucy DePriest
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.5.2.2]
b. 29 Jun 1913 d. 4 Jan 1986 [
=>
]
12
Clarice DePriest
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.5.2.3]
b. 25 Dec 1915 d. 23 Oct 1999
12
Joseph Smith DePriest
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.5.2.4]
b. 21 Jul 1921 d. 5 Aug 1946 [
=>
]
11
Mary Hortense Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.5.3]
b. 19 Dec 1884 d. 8 Jun 1885
11
Martha Eliza Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.5.4]
b. 23 Aug 1886 d. 2 Apr 1980
David Earl Shawcroft
b. 17 Jun 1887 d. 25 Nov 1969
12
Zina Shawcroft
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.5.4.1]
b. 9 Mar 1913 d. 17 Jun 1916
12
Alice Shawcroft
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.5.4.2]
b. 11 Nov 1914 d. 4 Dec 2001 [
=>
]
12
David Amel Shawcroft
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.5.4.3]
b. 11 Dec 1916 d. 22 Feb 1944
12
Hazel Shawcroft
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.5.4.4]
b. 12 Nov 1918 d. 16 May 1964 [
=>
]
12
Earl Smith Shawcroft
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.5.4.5]
b. 6 Oct 1920 d. 27 Feb 2001 [
=>
]
12
Lucy Elizabeth Shawcroft
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.5.4.6]
b. 28 Jan 1923 d. 5 Jan 1926
12
John Bennett Shawcroft
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.5.4.7]
b. 26 Mar 1925 d. 29 Feb 2012 [
=>
]
11
John Aikens Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.5.5]
b. 5 Oct 1888 d. 4 Apr 1970
Ione Decker
b. 16 Aug 1890 d. 30 Dec 1963
12
Emma Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.5.5.1]
b. 9 Apr 1913 d. 7 Jan 2004
12
Majorie Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.5.5.2]
b. 6 Mar 1915 d. 8 May 1915
12
Majel Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.5.5.3]
b. 13 Feb 1918 d. 30 Nov 1997
12
John Decker Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.5.5.4]
b. 26 May 1920 d. 1 Jun 2002
12
Morris Montell Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.5.5.5]
b. 8 Oct 1924 d. 28 Jan 2007
+
Effie Elizabeth Pruitt Nokes
b. 18 Sep 1897 d. 25 Dec 1996
11
Lucy Elizabeth Smith
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.5.6]
b. 24 May 1893 d. 23 Oct 1944
10
Elizabeth Emma Bennett
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.6]
b. 2 Jul 1856 d. 26 Feb 1940
Joseph Henry Fisher
b. 18 Oct 1856 d. 21 Nov 1940
11
Zina Elizabeth Fisher
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.6.1]
b. 6 Nov 1880 d. 14 Feb 1890
11
Martha Hannah Lees Fisher
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.6.2]
b. 19 Feb 1882 d. 23 May 1958
John Delbert Bushnell
b. 26 May 1883 d. 7 Apr 1975
12
Kelleth Delbert Bushnell
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.6.2.1]
b. 12 Feb 1908 d. 21 Aug 1983 [
=>
]
12
Wanda Bushnell
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.6.2.2]
b. 22 Feb 1909 d. 28 Oct 2002 [
=>
]
12
Joseph Avon Bushnell
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.6.2.3]
b. 21 Apr 1910 d. 4 Jun 1988 [
=>
]
12
Linda Bushnell
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.6.2.4]
b. 23 Nov 1912 d. 25 May 2001 [
=>
]
12
Elizabeth Bushnell
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.6.2.5]
b. 11 Nov 1923 d. 27 Apr 1970
11
Mary Emily Fisher
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.6.3]
b. 25 Oct 1883 d. 18 Feb 1890
11
Joseph Lees Fisher
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.6.4]
b. 5 Oct 1885 d. 14 Feb 1890
11
Albert Hyrum Fisher
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.6.5]
b. 28 Dec 1888 d. 10 Jul 1973
Alta Jane Beckstrand
b. 18 Aug 1894 d. 8 Dec 1973
12
Lela Fisher
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.6.5.1]
b. 9 Aug 1917 d. 10 Mar 1920
12
Carol Fisher
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.6.5.2]
b. 7 Nov 1919 d. 31 Jul 2009 [
=>
]
12
Wanda Fisher
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.6.5.3]
b. 20 Jan 1922 d. 21 Sep 2007 [
=>
]
12
Living
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.6.5.4]
12
Beulah Fisher
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.6.5.5]
b. 27 Apr 1929 d. 8 Dec 2017 [
=>
]
12
Living
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.6.5.6]
11
Angie Celestine Fisher
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.6.6]
b. 2 May 1893 d. 25 Nov 1971
William Connell
b. 4 Jan 1888 d. 28 Mar 1976
12
Maxine Connell
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.6.6.1]
b. 21 Jan 1916 d. 1 Jan 2012
12
Beth Connell
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.6.6.2]
b. 1 Nov 1919 d. 16 Aug 1995
11
James Clyde Fisher
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.6.7]
b. 5 Jun 1896 d. 19 Nov 1977
+
Mabel Alice Bushnell
b. 15 May 1900 d. 2 Jun 1924
+
Giovanna Maria Botero
b. 2 Aug 1891 d. 8 Oct 1976
11
Cecil Neil Fisher
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.6.8]
b. 8 Jul 1898 d. 2 Oct 1983
Thelma Beckstrand
b. 23 Sep 1900 d. 19 Apr 1982
12
Cecil Fisher
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.6.8.1]
12
Jay Neil Fisher
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.6.8.2]
b. 1 Mar 1920 d. 13 Nov 2011 [
=>
]
12
Ione Fisher
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.6.8.3]
b. 13 Jul 1923 d. 18 Sep 2006 [
=>
]
10
Elias Austin Bennett
[1.2.1.5.5.9.5.4.8.7]
b. 26 Jan 1858 d. 1 May 1861
+
Jane Smith
b. 1775
8
Mary Smith
[1.2.1.5.5.9.5.5]
b. 4 Jun 1775 d. 24 May 1844
Isaac Pierce
b. 11 Oct 1773 d. 9 Nov 1847
9
Eunice Pierce
[1.2.1.5.5.9.5.5.1]
b. 29 Apr 1799 d. 9 Jun 1803
9
Laura Pierce
[1.2.1.5.5.9.5.5.2]
b. 12 Nov 1801 d. 1803
9
Miranda Pierce
[1.2.1.5.5.9.5.5.3]
b. 17 Jun 1803 d. 16 Sep 1831
9
Horace Pierce
[1.2.1.5.5.9.5.5.4]
b. 8 Jun 1805 d. 20 May 1877
9
John S. Pierce
[1.2.1.5.5.9.5.5.5]
b. 6 Jun 1807 d. 3 Apr 1854
9
Susan Pierce
[1.2.1.5.5.9.5.5.6]
b. 20 Jun 1809 d. 4 Apr 1855
9
Mary Pierce
[1.2.1.5.5.9.5.5.7]
b. 25 Apr 1811
9
Elisabeth Ann Pierce
[1.2.1.5.5.9.5.5.8]
b. 2 Sep 1817 d. 16 May 1855
+
Joseph Brimhall
b. 1771
+
Charles Smith
b. 1772
8
Samuel Smith
[1.2.1.5.5.9.5.6]
b. 15 Sep 1777 d. 1 Apr 1830
Frances Wilcox
b. 1780
9
Charles Smith
[1.2.1.5.5.9.5.6.1]
b. 16 Apr 1817
9
Laura Smith
[1.2.1.5.5.9.5.6.2]
b. 1 Mar 1819
9
Horace Jay Smith
[1.2.1.5.5.9.5.6.3]
b. 12 Jul 1821
9
Sarah Smith
[1.2.1.5.5.9.5.6.4]
b. 11 Jun 1824
9
Elizabeth Smith
[1.2.1.5.5.9.5.6.5]
b. 16 Jul 1826
8
Silas Sanford Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7]
b. 1 Oct 1779 d. 13 Sep 1839
Ruth Steven
b. 1782 d. 10 Jan 1864
9
Charles Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.1]
b. 11 Nov 1806 d. 7 May 1809
9
Charity Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.2]
b. 1 Apr 1808 d. 2 Jun 1888
+
Richard Smith
b. 1808
9
Curtis Stevens Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.3]
b. 29 Oct 1809 d. 23 Sep 1861
Celia Euphrasia Ross
b. 1829 d. 28 Jun 1857
10
Ezra Ross Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.3.1]
b. 24 Jul 1852 d. 17 May 1853
10
William Curtis Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.3.2]
b. 14 Apr 1857 d. 1 Mar 1945
9
Samuel Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.4]
b. 3 Oct 1811 d. 7 Mar 1826
9
Stephen Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.5]
b. 8 Jan 1815 d. 20 Feb 1891
9
Susan Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.6]
b. 19 Oct 1817 d. 20 Nov 1846
9
Asahel Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.7]
b. 12 Oct 1819 d. 15 May 1834
Mary Aikens
b. 13 Aug 1797 d. 27 Apr 1877
9
Silas Sanford Smith, Jr
[1.2.1.5.5.9.5.7.8]
b. 26 Oct 1830 d. 11 Oct 1910
Martha Eliza Bennett
b. 24 Jan 1849 d. 6 May 1924
10
Sarah Ann Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.1]
b. 11 Jul 1868 d. 2 Feb 1900
+
Jesse Moroni Smith
b. 21 Nov 1858 d. 14 Mar 1937
+
John Cranmer Dalton
b. 9 Jan 1857 d. 31 Aug 1906
10
Martha Eliza Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.2]
b. 17 Mar 1870 d. 7 Jan 1957
Thales Hastings Haskell, Jr
b. 20 Oct 1868 d. 23 Apr 1952
11
Green Dwight Haskell
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.2.1]
b. 8 Dec 1899 d. 25 Apr 1975
Lena Opal Richardson
b. 5 Oct 1905 d. 24 Sep 1990
12
Dwight Richardson Haskell
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.2.1.1]
b. 12 Nov 1926 d. 20 Dec 2012
11
Mark Smith Haskell
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.2.2]
b. 21 Apr 1901 d. 21 Feb 1958
+
Mary Louise Jensen
b. 27 Jan 1906 d. 27 Apr 1971
11
Annie Haskell
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.2.3]
b. 10 Sep 1902 d. 11 Feb 1993
Weir Ferguson Smith
b. 6 May 1901 d. 5 Mar 1988
12
Ross Kelvin Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.2.3.1]
b. 28 Jun 1931 d. 24 Jun 1994
12
Jo Anne Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.2.3.2]
b. 29 Jan 1935 d. 22 Jan 2003 [
=>
]
11
Thales Edward Haskell
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.2.4]
b. 14 Oct 1904 d. 22 Dec 1982
Edith Olson
b. 20 Oct 1902 d. 16 Dec 1980
12
Maralyne Haskell
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.2.4.1]
b. 23 Jun 1928 d. 5 Jun 2012 [
=>
]
11
Hattie Haskell
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.2.5]
b. 3 Oct 1907 d. 1 Jan 1963
+
Milton Hicks
b. 25 Oct 1915 d. 17 Mar 1983
10
Curtis Bennett Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.3]
b. 23 Oct 1871 d. 28 Nov 1942
+
Ursula Pearl Harrison
b. 25 Jul 1879 d. 10 Nov 1960
10
Elias Austin Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.4]
b. 4 Mar 1874 d. 27 Jun 1925
Jessie Arlettia Block
b. 20 Feb 1879 d. 22 Apr 1958
11
Eva Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.4.1]
b. 8 Jun 1899 d. 22 Aug 1979
Cecil Gee Sumner
b. 14 Aug 1905 d. 1 Apr 1991
12
Eve Smith Sumner
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.4.1.1]
b. 24 Jul 1935 d. 27 Sep 1972
11
Austin Block Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.4.2]
b. 26 Dec 1900 d. 1 Aug 1976
Helen Taggart
b. 29 Jul 1911 d. 22 Jul 2003
12
Austin Taggart Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.4.2.1]
b. 28 Nov 1938 d. 30 Oct 1987
11
Elias Penn Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.4.3]
b. 1 Oct 1902 d. 1 Feb 1976
+
Louise Harris
b. 25 Apr 1902 d. 28 Nov 1955
11
Mack Bennett Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.4.4]
b. 23 Nov 1905 d. 1975
Marion Eveline Jensen
b. 12 Apr 1908 d. 16 Sep 1979
12
Debra Annette Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.4.4.1]
b. 15 Dec 1951 d. 19 Apr 1987
11
Rex Poulson Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.4.5]
b. 3 Nov 1910 d. 22 Mar 1925
11
Amy Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.4.6]
b. 26 Sep 1913 d. 20 Mar 1994
Howard Eugene Baysinger
b. 23 Aug 1912 d. Nov 1978
12
Austin Smith Baysinger
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.4.6.1]
b. 26 Feb 1947 d. 10 Jan 2009
10
Emma Jane Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.5]
b. 4 Apr 1876 d. 16 Jan 1951
Edwin Cleveland Dibble
b. 1 Sep 1869 d. 28 Jan 1947
11
Edwin Smith Dibble
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.5.1]
b. 5 Dec 1901 d. 12 Sep 2003
+
Ruth Emily Gollaher
b. 9 Sep 1905 d. 26 Nov 1985
11
George Smith Dibble
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.5.2]
b. 29 Mar 1904 d. 1 Jun 1992
+
Cleone Atwood
b. 6 Jul 1908 d. 25 Nov 1990
11
Joseph Smith Dibble
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.5.3]
b. 6 Jun 1907 d. 17 Sep 1973
Blanche Woodruff McEwan
b. 6 Apr 1915 d. 23 Jun 1985
12
Elizabeth Jo Dibble
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.5.3.1]
b. 21 Apr 1937 d. 15 Feb 1970
11
Asael Smith Dibble
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.5.4]
b. 31 Jul 1910 d. 16 Dec 2000
Claire Fisher
b. 2 Dec 1913 d. 18 Mar 1993
12
Living
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.5.4.1]
11
Verlie Dibble
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.5.5]
b. 25 Nov 1917 d. 19 Sep 1985
+
Clyde Fielding Smith
b. 11 Oct 1903 d. 6 Dec 1980
10
George Essex Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.6]
b. 24 Sep 1878 d. 26 May 1949
Vista May Rogers
b. 27 Aug 1880 d. 27 Jun 1954
11
May Rhue Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.6.1]
b. 8 Nov 1902 d. 6 Jul 1989
+
William Milton Holmes
b. 12 Oct 1904 d. 19 Jan 1987
11
George Essex Smith, Jr
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.6.2]
b. 5 Aug 1904 d. 20 Jan 1985
+
Cella King
b. 6 Feb 1907 d. 8 Feb 1980
+
Laura Verina Crowther
b. 25 Nov 1903 d. 14 Jul 1989
11
Margaret Eliza Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.6.3]
b. 17 May 1906 d. 6 May 1996
+
Charles Frederick Chapman
b. 16 Oct 1898 d. 23 Nov 1969
11
Silas Bennett Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.6.4]
b. 16 Jan 1908 d. 27 Jan 1908
11
Sanford Snow Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.6.5]
b. 20 Feb 1911 d. 6 Dec 1928
11
Martha Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.6.6]
b. 20 Aug 1915 d. 21 Nov 1915
11
Milton Ralph Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.6.7]
b. 26 Oct 1918 d. 13 Aug 1986
+
Carol Rose Hiatt
b. 30 Aug 1921 d. 22 Sep 2002
10
Erastus Snow Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.7]
b. 18 Aug 1881 d. 16 Sep 1890
10
Hyrum Asahel Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.8]
b. 15 Sep 1883 d. 16 Jul 1941
Rebecca Pearl Hodson
b. 26 Oct 1883 d. 17 Oct 1965
11
Inez Myrtle Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.8.1]
b. 17 Nov 1905 d. 1 Aug 1994
+
William Uffo Uffens
b. 14 Jan 1908 d. 7 Mar 1997
11
Asahel Earl Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.8.2]
b. 29 Mar 1910 d. 3 Jan 1969
Nora Ann Porter
b. 11 Jul 1908 d. 16 Jun 1992
12
Donald Porter Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.8.2.1]
b. 3 Apr 1949 d. 4 Jul 2011
11
Annie Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.8.3]
b. 24 Nov 1912 d. 23 Feb 1913
11
Fay Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.8.4]
b. 18 Feb 1915 d. 9 Jan 2000
+
Woodrow Mitchell Lewis
b. 24 Feb 1914 d. 1 Aug 1984
11
Donald Hodson Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.8.5]
b. 19 May 1923 d. 12 Aug 1943
10
Lucy Edith Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.9]
b. 12 Aug 1886 d. 6 Jan 1963
David DuBois Dibble
b. 13 Sep 1876 d. 24 Apr 1975
11
Frances Dibble
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.9.1]
b. 18 Dec 1923 d. 16 Sep 1990
Scott Monroe McKay
b. 6 Sep 1921 d. 14 Mar 1983
12
Frances Ann McKay
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.9.1.1]
b. 28 Jul 1953 d. 18 Nov 2006
12
Living
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.9.1.2]
12
Donald David McKay
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.9.1.3]
b. 6 Apr 1956 d. 30 May 1956
+
Charles Dorsey Warren
b. 15 May 1905 d. 23 Dec 1983
11
David Smith Dibble
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.9.2]
b. 2 Apr 1928 d. 27 Dec 1993
12
Ann Dibble
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.9.2.1]
b. 13 Nov 1951 d. 30 May 2008
10
Joseph Frances Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.10]
b. 7 Apr 1889 d. 14 Feb 1920
Lavinia Ann Webster
b. 2 Mar 1890 d. 29 Nov 1962
11
Verlie W Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.10.1]
b. 14 Oct 1915 d. 17 Feb 2001
Gordon Beard Taylor
b. 3 May 1914 d. 16 Dec 2001
12
Roma Diane Taylor
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.10.1.1]
b. 21 Dec 1937 d. 24 Dec 1937
11
Francis Bennett Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.10.2]
b. 29 Oct 1917 d. 12 Apr 1978
+
Alice M Hummel
b. 1909
11
Arthur Agle Millecan
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.10.3]
b. 30 Jul 1922 d. 10 Apr 2003
Betty Margaret Stoddard
b. 15 Dec 1921 d. 21 Oct 2012
12
Arthur Stoddard Millecan
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.10.3.1]
b. 17 Jun 1961 d. 18 Jun 1961
10
Clara Estella Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.11]
b. 4 Aug 1891 d. 10 May 1992
10
Verlie Dorcas Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.12]
b. 14 Oct 1894 d. 23 Dec 1894
Clarinda Rich
b. 10 Jan 1835 d. 18 Mar 1864
10
Silas Sanford Smith, Jr
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.13]
b. 10 Jul 1853 d. 19 Jan 1911
10
Jesse Joel Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.14]
b. 4 Nov 1857 d. 12 Sep 1905
10
Leonora Abigail Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.15]
b. 22 Oct 1859 d. 26 Sep 1863
10
Stephen Augustus Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.16]
b. 1 Nov 1861 d. 21 Oct 1939
10
Ella Clarinda Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.17]
b. 9 Mar 1864 d. 2 Jun 1913
Sally Ann Ricks
b. 28 Dec 1832 d. 30 Jun 1864
10
John Aikens Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.18]
b. 19 Mar 1854 d. 9 Jan 1923
Emily Jane Bennett
b. 17 Jan 1854 d. 4 May 1903
11
Emily Jane Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.18.1]
b. 5 May 1878 d. 21 Feb 1958
Levi Dunn
b. 9 Jan 1880 d. 9 Feb 1968
12
Emily Dunn
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.18.1.1]
b. 27 Mar 1911 d. 15 Jan 1988 [
=>
]
12
Alton Smith Dunn
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.18.1.2]
b. 19 Feb 1914 d. 6 Oct 1976
12
Leon Bennett Dunn
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.18.1.3]
b. 15 May 1916 d. 17 Feb 1975
12
Marcel Harmon Dunn
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.18.1.4]
b. 12 Jan 1919 d. 24 Aug 2002
11
Sarah Ann Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.18.2]
b. 23 Apr 1883 d. 22 Feb 1969
Joseph Beharm DePriest
b. 27 Jan 1881 d. 15 May 1969
12
Emily Lenella DePriest
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.18.2.1]
b. 22 Oct 1909 d. 17 Nov 1990
12
Lucy DePriest
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.18.2.2]
b. 29 Jun 1913 d. 4 Jan 1986 [
=>
]
12
Clarice DePriest
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.18.2.3]
b. 25 Dec 1915 d. 23 Oct 1999
12
Joseph Smith DePriest
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.18.2.4]
b. 21 Jul 1921 d. 5 Aug 1946 [
=>
]
11
Mary Hortense Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.18.3]
b. 19 Dec 1884 d. 8 Jun 1885
11
Martha Eliza Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.18.4]
b. 23 Aug 1886 d. 2 Apr 1980
David Earl Shawcroft
b. 17 Jun 1887 d. 25 Nov 1969
12
Zina Shawcroft
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.18.4.1]
b. 9 Mar 1913 d. 17 Jun 1916
12
Alice Shawcroft
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.18.4.2]
b. 11 Nov 1914 d. 4 Dec 2001 [
=>
]
12
David Amel Shawcroft
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.18.4.3]
b. 11 Dec 1916 d. 22 Feb 1944
12
Hazel Shawcroft
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.18.4.4]
b. 12 Nov 1918 d. 16 May 1964 [
=>
]
12
Earl Smith Shawcroft
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.18.4.5]
b. 6 Oct 1920 d. 27 Feb 2001 [
=>
]
12
Lucy Elizabeth Shawcroft
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.18.4.6]
b. 28 Jan 1923 d. 5 Jan 1926
12
John Bennett Shawcroft
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.18.4.7]
b. 26 Mar 1925 d. 29 Feb 2012 [
=>
]
11
John Aikens Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.18.5]
b. 5 Oct 1888 d. 4 Apr 1970
Ione Decker
b. 16 Aug 1890 d. 30 Dec 1963
12
Emma Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.18.5.1]
b. 9 Apr 1913 d. 7 Jan 2004
12
Majorie Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.18.5.2]
b. 6 Mar 1915 d. 8 May 1915
12
Majel Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.18.5.3]
b. 13 Feb 1918 d. 30 Nov 1997
12
John Decker Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.18.5.4]
b. 26 May 1920 d. 1 Jun 2002
12
Morris Montell Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.18.5.5]
b. 8 Oct 1924 d. 28 Jan 2007
+
Effie Elizabeth Pruitt Nokes
b. 18 Sep 1897 d. 25 Dec 1996
11
Lucy Elizabeth Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.18.6]
b. 24 May 1893 d. 23 Oct 1944
10
Mary Eleanor Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.19]
b. 26 Sep 1857 d. 25 Nov 1888
10
Hortense Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.20]
b. 14 Oct 1859 d. 8 Sep 1945
10
Albert Ricks Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.21]
b. 1 Apr 1862 d. 17 May 1905
10
Hyrum Barton Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.8.22]
b. 16 Jun 1864 d. 9 Aug 1864
9
John Aikens Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.9]
b. 6 Jul 1832 d. 27 Nov 1838
9
Jesse Nathaniel Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.10]
b. 2 Dec 1834 d. 5 Jun 1906
Augusta Maria Outzen
b. 14 Jan 1854 d. 26 Apr 1932
10
Georgianna Bathsheba Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.1]
b. 16 Aug 1870 d. 14 May 1946
10
Augusta Gerhardina "Dina" Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.2]
b. 14 Jul 1872 d. 9 Jan 1940
10
Robert Christian Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.3]
b. 27 Nov 1874 d. 9 Apr 1920
10
Martha Amelia Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.4]
b. 17 Jul 1877 d. 10 Aug 1931
James Madison Flake
b. 8 Nov 1859 d. 4 Feb 1946
11
Donald Christian Flake
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.4.1]
b. 24 Oct 1897 d. 4 Jan 1979
11
Augusta Flake
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.4.2]
b. 4 Mar 1899 d. 1 Jun 1993
11
Silas Eugene Flake
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.4.3]
b. 9 Sep 1900 d. 19 Dec 1983
+
Ruth Whipple
b. 27 Dec 1910 d. 16 Sep 1994
11
Virgil Maeser Flake
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.4.4]
b. 24 Feb 1902 d. 19 Jan 1966
11
Joseph Marion Flake
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.4.5]
b. 8 Oct 1903 d. 24 Jan 1982
11
Thelma Flake
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.4.6]
b. 3 Jul 1905 d. 7 Dec 1923
11
Bruce Merlin Flake
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.4.7]
b. 27 Jan 1907 d. 10 May 1971
11
Vernon Smith Flake
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.4.8]
b. 23 Dec 1908 d. 15 Sep 1965
11
Mary Flake
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.4.9]
b. 10 Aug 1910 d. 27 Aug 1910
11
Anna Flake
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.4.10]
b. 24 Sep 1911 d. 20 Mar 2000
11
Ruth Flake
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.4.11]
b. 23 Nov 1913 d. 6 Jun 1975
11
Vincent Madison Flake
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.4.12]
b. 19 Jul 1915 d. 19 Aug 1988
11
Aften Flake
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.4.13]
b. 8 Aug 1916 d. 1 Oct 2008
11
Fost Wilson Flake
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.4.14]
b. 12 Mar 1918 d. 31 Aug 1997
10
Asahel Henry Smith, Sr
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.5]
b. 5 Dec 1880 d. 7 Sep 1947
10
Anna Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.6]
b. 6 Aug 1883 d. 8 Oct 1910
10
Rebecca Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.7]
b. 23 Oct 1886 d. 3 Nov 1960
10
Rachel Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.8]
b. 1 Jan 1889 d. 13 Jul 1940
10
Sophronia Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.9]
b. 8 Apr 1892 d. 11 Oct 1953
10
Natalia Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.10]
b. 3 Apr 1894 d. 2 Jun 1978
10
Millie Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.11]
b. 25 Dec 1897 d. 3 Oct 1931
Emma Seraphine West
b. 3 Jan 1836 d. 15 Oct 1910
10
Emma Seraphine Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.12]
b. 12 Aug 1853 d. 29 Dec 1909
10
Mary Josephine Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.13]
b. 23 Jan 1855 d. 17 Dec 1894
10
Hannah Daphne Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.14]
b. 22 Mar 1857 d. 10 May 1937
10
Eliza Snow Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.15]
b. 23 Feb 1859 d. 27 Dec 1927
10
Jesse Nathaniel Smith, Jr
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.16]
b. 16 May 1861 d. 13 Jul 1912
10
Sarah Elizabeth Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.17]
b. 2 Feb 1866 d. 15 Sep 1892
10
Silas Derryfield Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.18]
b. 9 Sep 1867 d. 26 Feb 1956
10
John Walter Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.19]
b. 10 Jun 1871 d. 7 May 1936
10
Samuel Francis Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.20]
b. 21 Nov 1873 d. 24 Jan 1954
Margaret Fletcher West
b. 22 May 1838 d. 1 Feb 1864
10
Adelaide Margaret Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.21]
b. 13 Feb 1857 d. 29 Oct 1927
10
Joseph West Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.22]
b. 6 Sep 1859 d. 22 Dec 1944
Janet Mauretta Johnson
b. 17 Dec 1848 d. 21 May 1933
10
Susan Janet Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.23]
b. 15 Sep 1868 d. 15 Dec 1960
Heber Jarvis
b. 14 Oct 1860 d. 8 Oct 1953
11
Heber Jarvis, Jr
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.23.1]
b. 15 Apr 1885 d. 26 Mar 1886
11
Jesse Rulon Jarvis
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.23.2]
b. 13 Jun 1886 d. 10 Jun 1960
Harriet Whipple
b. 23 Mar 1890 d. 24 Mar 1956
12
Jesse Rulon Jarvis, Jr
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.23.2.1]
b. 27 May 1909 d. 24 Jun 1990 [
=>
]
12
Marvin Earl Jarvis
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.23.2.2]
b. 24 Nov 1910 d. 26 Jan 1991 [
=>
]
12
Oliver Temple Jarvis
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.23.2.3]
b. 13 Feb 1913 d. 5 Aug 1914
12
Edith Jarvis
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.23.2.4]
b. 1 Jan 1915 d. 16 Nov 1979 [
=>
]
12
Grant Stanley Jarvis
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.23.2.5]
b. 31 Jan 1918 d. 14 May 1923
12
Erma Jarvis
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.23.2.6]
b. 21 Jul 1920 d. 23 Feb 1922
12
Eva Jarvis
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.23.2.7]
b. 6 Feb 1922 d. 26 Feb 1933
12
Rex Whipple Jarvis
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.23.2.8]
b. 27 Jan 1924 d. 12 Mar 1933
12
Wayne Heber Jarvis
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.23.2.9]
b. 14 Sep 1927 d. 1 May 1931
12
Joy Smith Jarvis
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.23.2.10]
b. 24 Feb 1930 d. 19 Sep 1930
11
Maude Jarvis
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.23.3]
b. 26 Jan 1888 d. 14 Mar 1974
11
George Jarvis
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.23.4]
b. 21 Mar 1889 d. 28 Aug 1981
11
Janet Jarvis
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.23.5]
b. 10 Feb 1891 d. 20 Oct 1944
11
Annie Jarvis
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.23.6]
b. 22 Apr 1892 d. 5 Apr 1893
11
Joseph Smith Jarvis
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.23.7]
b. 6 Mar 1894 d. 12 Jun 1989
11
Pearl Jarvis
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.23.8]
b. 7 Aug 1896 d. 12 Dec 1983
11
William Prior Jarvis
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.23.9]
b. 22 Sep 1898 d. 17 Mar 1973
11
Susie Jarvis
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.23.10]
b. 1 May 1901 d. 18 May 1929
11
Thomas Earl Jarvis
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.23.11]
b. 25 Apr 1903 d. 17 Apr 1906
11
Silas Fielding Jarvis
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.23.12]
b. 28 Feb 1905 d. 19 Oct 1983
11
Margaret Jarvis
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.23.13]
b. 1 Oct 1906 d. 19 Mar 1994
11
Ethel Jarvis
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.23.14]
b. 18 Oct 1908 d. 13 Sep 2006
11
Rudger LaVerl Jarvis
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.23.15]
b. 15 May 1911 d. 29 Jun 2002
10
Ellen Mauretta Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.24]
b. 20 Sep 1871 d. 1 Aug 1872
10
Sariah Anna Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.25]
b. 21 Feb 1873 d. 26 Dec 1922
10
Agnes Maud Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.26]
b. 11 Jul 1874 d. 7 Oct 1878
10
Julia Johnson Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.27]
b. 20 Oct 1875 d. 27 Apr 1956
10
Priscilla Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.28]
b. 10 May 1877 d. 17 Jan 1954
10
Editha Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.29]
b. 8 Sep 1878 d. 28 Jul 1931
10
Lucy Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.30]
b. 24 Jun 1880 d. 15 Nov 1951
William Howard Shumway
b. 20 Jul 1877 d. 20 Jun 1945
11
Donnetta Shumway
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.30.1]
b. 27 Oct 1899 d. 9 Jan 1955
11
Howard Burton Shumway
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.30.2]
b. 5 Mar 1901 d. 21 Jul 1933
11
Priscilla Shumway
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.30.3]
b. 2 Mar 1903 d. 15 Jan 1992
11
Kenneth Smith Shumway
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.30.4]
b. 13 Feb 1905 d. 10 Oct 1972
11
Charles Richard Shumway
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.30.5]
b. 12 Aug 1907 d. 17 Dec 1990
11
Elizabeth Shumway
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.30.6]
b. 25 Jan 1910 d. 6 Aug 1993
11
Jesse N Smith Shumway
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.30.7]
b. 18 Mar 1912 d. 14 Dec 2000
Leoma Blanche Peterson
b. 3 Sep 1910 d. 3 Mar 1998
12
Marlene Shumway
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.30.7.1]
b. 26 Jul 1936 d. 16 Oct 1984
11
Janet Smith Shumway
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.30.8]
b. 30 Jul 1914 d. 22 Dec 1982
11
Lucy Shumway
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.30.9]
b. 10 Oct 1917 d. 28 Nov 1998
11
Margaret Shumway
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.30.10]
b. 10 Feb 1920 d. 2 Feb 2013
11
Julia Rosalind Shumway
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.30.11]
b. 20 Apr 1922 d. 22 Aug 2011
11
Nephi Grant Shumway
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.30.12]
b. 8 Mar 1925 d. 15 Oct 1944
10
Margaret Fife Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.31]
b. 6 Sep 1882 d. 28 Mar 1969
10
Ruth Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.32]
b. 17 Mar 1884 d. 31 Dec 1956
10
Esther Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.33]
b. 26 Oct 1887 d. 8 Dec 1975
10
Elias Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.34]
b. 1 Aug 1889 d. 23 Dec 1961
10
Leah Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.35]
b. 13 Aug 1891 d. 17 Feb 1976
Emma Ellen Larson
b. 6 Apr 1863 d. 2 Jun 1943
10
Hyrum Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.36]
b. 15 Dec 1882 d. 22 Mar 1971
10
Caroline Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.37]
b. 19 Nov 1884 d. 19 Jan 1924
10
Don Carlos Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.38]
b. 26 Sep 1886 d. 28 Oct 1967
10
Lorana Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.39]
b. 29 Nov 1888 d. 25 Apr 1979
10
Lehi Larson Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.40]
b. 19 Mar 1891 d. 28 Oct 1918
10
George Albert Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.41]
b. 7 May 1893 d. 31 Jan 1965
10
Aikens Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.42]
b. 29 Jul 1899 d. 17 Jul 1960
10
Myrtle Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.43]
b. 25 Oct 1901 d. 10 Jan 1977
10
Matthias Foss Cowley Smith
[1.2.1.5.5.9.5.7.10.44]
b. 1 Oct 1905 d. 5 Feb 1990
8
Patriarch John Smith
[1.2.1.5.5.9.5.8]
b. 16 Jul 1781 d. 23 May 1854
Clarissa Loomis Lyman
b. 27 Jun 1790 d. 14 Feb 1854
9
Daughter Smith
[1.2.1.5.5.9.5.8.1]
b. 9 May 1816 d. 9 May 1816
9
George Albert Smith
[1.2.1.5.5.9.5.8.2]
b. 26 Jun 1817 d. 1 Sep 1875
Bathsheba Wilson Bigler
b. 3 May 1822 d. 20 Sep 1910
10
George Albert Smith
[1.2.1.5.5.9.5.8.2.1]
b. 7 Jul 1842 bur. 8 Jan 1876
10
Son Smith
[1.2.1.5.5.9.5.8.2.2]
b. Abt 1844
10
Bathsheba Kate Smith
[1.2.1.5.5.9.5.8.2.3]
b. 14 Aug 1844 d. 22 Dec 1920
10
Daughter Smith
[1.2.1.5.5.9.5.8.2.4]
b. Abt 1846
10
John Henry Smith
[1.2.1.5.5.9.5.8.2.5]
b. 4 Apr 1847 d. 4 Apr 1847
Nancy A Clement
b. 31 Oct 1815 d. 26 Mar 1847
10
Lydia Crane
[1.2.1.5.5.9.5.8.2.6]
b. 1800 d. Oct 1827
10
Nancy Alida Crane
[1.2.1.5.5.9.5.8.2.7]
b. 20 Mar 1807 d. Dec 1882
10
Nancy Adelia Smith
[1.2.1.5.5.9.5.8.2.8]
b. 20 Mar 1846 d. 17 Apr 1847
10
Ellen Smith
[1.2.1.5.5.9.5.8.2.9]
b. Dec 1846 d. Apr 1847
Lucy Messerve Smith
b. 9 Feb 1817 d. 5 Oct 1892
10
Don Carlos Smith
[1.2.1.5.5.9.5.8.2.10]
b. 11 Aug 1846 d. 21 Jul 1847
10
Joel Smith
[1.2.1.5.5.9.5.8.2.11]
b. 6 Aug 1850 d. 6 Aug 1850
Zilpha Stark
b. 3 Jul 1818 d. 19 Sep 1887
10
Zilpha Adelade Smith
[1.2.1.5.5.9.5.8.2.12]
b. 12 Mar 1846 d. 12 May 1846
10
Joseph Smith
[1.2.1.5.5.9.5.8.2.13]
b. 2 Jan 1850 d. 8 Oct 1850
10
Mary Amelia Smith
[1.2.1.5.5.9.5.8.2.14]
b. 14 Feb 1852 d. 20 Mar 1915
Sarah Ann Libby
b. 7 May 1818 d. 12 Jun 1851
10
John Henry Smith
[1.2.1.5.5.9.5.8.2.15]
b. 18 Sep 1848 d. 13 Oct 1911
Sarah Farr
b. 30 Oct 1849 d. 4 Feb 1921
11
John Henry Smith
[1.2.1.5.5.9.5.8.2.15.1]
b. 22 Feb 1868 d. 20 Sep 1868
11
George Albert Smith
[1.2.1.5.5.9.5.8.2.15.2]
b. 4 Apr 1870 d. 4 Apr 1951
Lucy Emily Woodruff
b. 10 Jan 1869 d. 5 Nov 1937
12
Emily Smith
[1.2.1.5.5.9.5.8.2.15.2.1]
b. 20 Nov 1895 d. 28 Feb 1973
12
Edith Elliott
[1.2.1.5.5.9.5.8.2.15.2.2]
b. 10 Nov 1899 d. 13 Jun 1977
12
George Albert Smith, Jr
[1.2.1.5.5.9.5.8.2.15.2.3]
b. 10 Sep 1905 d. 11 Oct 1969
11
Lorin Farr Smith
[1.2.1.5.5.9.5.8.2.15.3]
b. 22 Apr 1872 d. 9 Jul 1872
11
Don Carlos Smith
[1.2.1.5.5.9.5.8.2.15.4]
b. 18 Mar 1874 d. 5 Jan 1927
11
Ezra Chase Smith
[1.2.1.5.5.9.5.8.2.15.5]
b. 21 Sep 1876 d. 28 Apr 1951
11
Charles Warren Smith
[1.2.1.5.5.9.5.8.2.15.6]
b. 3 Aug 1879 d. 7 Dec 1879
11
Winslow Farr Smith
[1.2.1.5.5.9.5.8.2.15.7]
b. 19 Jan 1881 d. 25 Dec 1966
11
Nathaniel Libby Smith
[1.2.1.5.5.9.5.8.2.15.8]
b. 19 Jun 1883 d. 1 Jul 1935
11
Joseph Harmon Smith
[1.2.1.5.5.9.5.8.2.15.9]
b. 17 Dec 1884 d. 23 May 1942
11
Tirzah Priscilla Smith
[1.2.1.5.5.9.5.8.2.15.10]
b. 11 Jun 1887 d. 12 Jun 1951
11
Elsie Louise Smith
[1.2.1.5.5.9.5.8.2.15.11]
b. 19 Oct 1891 d. 26 Dec 1956
Josephine Groesbeck
b. 13 Oct 1857 d. 1 Nov 1948
11
Sarah Ann Smith
[1.2.1.5.5.9.5.8.2.15.12]
b. 2 Oct 1878 d. 11 Feb 1938
11
Nicholas Groesbeck Smith
[1.2.1.5.5.9.5.8.2.15.13]
b. 20 Jun 1881 d. 27 Oct 1945
11
Joseph Harmon Smith
[1.2.1.5.5.9.5.8.2.15.14]
b. 17 Dec 1884 d. 23 May 1942
11
Lucy Smith
[1.2.1.5.5.9.5.8.2.15.15]
b. 24 Dec 1887 d. 7 Sep 1900
11
Elizabeth Smith
[1.2.1.5.5.9.5.8.2.15.16]
b. 30 Jan 1890 d. 9 Mar 1973
11
Glen Grosbeck Smith
[1.2.1.5.5.9.5.8.2.15.17]
b. 19 Sep 1893 d. 19 Jun 1970
11
Arzella Smith
[1.2.1.5.5.9.5.8.2.15.18]
b. 5 Nov 1895 d. 4 Jan 1969
11
Josephine Smith
[1.2.1.5.5.9.5.8.2.15.19]
b. 3 Jan 1898 d. 12 Aug 1973
Hannah Maria Libby
b. 29 Jun 1828 d. 21 Sep 1906
10
Charles Warren Smith
[1.2.1.5.5.9.5.8.2.16]
b. 16 Jan 1849 d. 25 Jan 1903
10
Sarah Maria Smith
[1.2.1.5.5.9.5.8.2.17]
b. 1 Jan 1856 d. 16 Jan 1912
10
Eunice Albertine Smith
[1.2.1.5.5.9.5.8.2.18]
b. 6 Mar 1860 d. 4 Oct 1861
10
George Albert Smith
[1.2.1.5.5.9.5.8.2.19]
b. 7 Apr 1862 d. 28 Oct 1863
10
Grace Libby Smith
[1.2.1.5.5.9.5.8.2.20]
b. 14 May 1865 d. 27 Feb 1939
Susan Elizabeth West
b. 4 Dec 1833 d. 6 Jul 1935
10
Clarissa West Smith
[1.2.1.5.5.9.5.8.2.21]
b. 21 Apr 1859 d. 8 Mar 1930
10
Margaret West Smith
[1.2.1.5.5.9.5.8.2.22]
b. 6 Dec 1862 d. 18 Jun 1913
10
Elizabeth Smith
[1.2.1.5.5.9.5.8.2.23]
b. 28 Sep 1866 d. 6 Jan 1921
10
Priscilla Smith
[1.2.1.5.5.9.5.8.2.24]
b. 11 Jun 1869 d. 3 Nov 1907
10
Emma Pearl Smith
[1.2.1.5.5.9.5.8.2.25]
b. 19 Apr 1871 d. 6 Oct 1905
9
Caroline Clara Smith
[1.2.1.5.5.9.5.8.3]
b. 6 Jun 1820 d. 8 Jan 1895
Thomas Callister
b. 8 Jul 1821 d. 1 Dec 1880
10
Thomas Callister
[1.2.1.5.5.9.5.8.3.1]
b. 13 Sep 1846 d. 8 May 1847
10
Clarissa Callister
[1.2.1.5.5.9.5.8.3.2]
b. 28 May 1848 d. 4 Oct 1848
10
Clara Caroline Callister
[1.2.1.5.5.9.5.8.3.3]
b. 18 Apr 1850 d. 22 Sep 1892
10
Philomela Callister
[1.2.1.5.5.9.5.8.3.4]
b. 11 Jul 1851 d. 22 Feb 1879
10
Mary Maranda Callister
[1.2.1.5.5.9.5.8.3.5]
b. 17 Aug 1853 d. 14 May 1930
10
Samuel Jay Callister
[1.2.1.5.5.9.5.8.3.6]
b. 14 Jan 1856 d. 14 Jan 1856
10
Bathsheba Smith Callister
[1.2.1.5.5.9.5.8.3.7]
b. 21 Sep 1860 d. 1 Nov 1860
9
John Lyman Smith
[1.2.1.5.5.9.5.8.4]
b. 17 Nov 1828 d. 21 Feb 1898
8
Susannah Smith
[1.2.1.5.5.9.5.9]
b. 18 May 1783 d. 22 Mar 1849
+
John Hall
8
Stephen Smith
[1.2.1.5.5.9.5.10]
b. 23 Apr 1785 d. 25 Jul 1802
+
Sally Hadley
8
Sarah Smith
[1.2.1.5.5.9.5.11]
b. 16 May 1789 d. 27 May 1824
Joseph Sanford
b. 1785 d. 11 Sep 1825
9
Martin Sanford
[1.2.1.5.5.9.5.11.1]
b. 24 Sep 1811 d. 24 Nov 1817
9
Martin Sanford
[1.2.1.5.5.9.5.11.2]
b. 4 Nov 1812 d. 3 Dec 1820
9
Joseph Sanford
[1.2.1.5.5.9.5.11.3]
b. 1813 d. 1816
9
Charlette Sanford
[1.2.1.5.5.9.5.11.4]
b. 4 Mar 1814 d. Abt 1858
9
William Wallace Sanford
[1.2.1.5.5.9.5.11.5]
b. 13 Jun 1816 d. 1844
9
John Lyman Sanford
[1.2.1.5.5.9.5.11.6]
b. 20 May 1818
5
Priscilla Gould
[1.2.1.5.6]
b. 2 Nov 1674 d. 16 Jun 1715
5
Captain Joseph Gould
[1.2.1.5.7]
b. 24 Aug 1677 d. 4 Apr 1753
5
Mary Gould
[1.2.1.5.8]
b. 16 Jun 1681 d. 11 May 1689
3
Anne Deacon
[1.2.2]
b. 22 Jun 1600 d. 22 Oct 1619
+
Richard Paine
b. 20 Feb 1596 bur. 18 May 1645
3
Thomas Deacon
[1.2.3]
b. 14 Feb 1602 d. Abt 1608
3
Elisha Deacon
[1.2.4]
b. 9 Jan 1603 d. 24 Oct 1658
+
Nancy
c. Abt 1608
3
Sarah Deacon
[1.2.5]
b. 25 Dec 1604
3
Martha Deacon
[1.2.6]
b. 22 Aug 1613
3
Daughter Deacon
[1.2.7]
b. 23 Oct 1619 d. Oct 1619
3
Son Deacon
[1.2.8]
b. 23 Oct 1619 d. 23 Oct 1619
2
Benjamin Field
[1.3]
b. 22 Aug 1581 d. 3 Sep 1581
2
Hannah Field
[1.4]
b. 22 Mar 1584
2
Seth Field
[1.5]
c. 25 Sep 1586 bur. 15 Jan 1588
2
Rebecka Field
[1.6]
c. 28 Sep 1589