Home Page
|
What's New
|
Photos
|
Histories
|
Headstones
|
Reports
|
Surnames
Search
First Name:
Last Name:
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Suomalainen
Svenska
Eleanor Wickersley
Abt 1509 - 1532 (23 years)
Submit Photo / Document
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Submit Photo / Doc
Worksheet
Family
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Eleanor Wickersley
[1]
b. Abt 1509 d. 1532
Richard Swift
b. 1505 d. 3 Sep 1558
2
Thomas Swift
[1.1]
b. Abt 1525
2
Isabella Swift
[1.2]
b. 1531 d. 1557
John Boithes
b. 1525 d. 27 Mar 1569
3
Thomas Boithes
[1.2.1]
b. 1550
3
Isabella Boithes
[1.2.2]
b. 1552
3
Robert Boithes
[1.2.3]
b. 1552
3
Henry Boithes
[1.2.4]
c. 26 Jan 1555
3
Genet Boithes
[1.2.5]
c. 2 Jul 1555
3
Grace Boithes
[1.2.6]
c. 16 Jul 1557 d. 9 Mar 1628
Henry Best
b. 20 Apr 1554 d. Sep 1622
4
Michael Best
[1.2.6.1]
b. 14 Aug 1578
4
Judith Best
[1.2.6.2]
b. 12 Feb 1580
4
John Best
[1.2.6.3]
b. Abt 1584 d. 21 Jun 1654
Jane Robinsonne
b. 1587 d. 1607
5
Elizabeth Best
[1.2.6.3.1]
b. 1607 d. 27 Feb 1661
William Enos Hunt
b. 25 Jan 1604 d. 2 Oct 1677
6
Nehemiah Hunt
[1.2.6.3.1.1]
b. Jun 1631 d. 6 Mar 1717
Mary Toll
b. 8 Dec 1643 d. 29 Aug 1727
7
Mary Hunt
[1.2.6.3.1.1.1]
b. 28 Sep 1664 d. 1 Dec 1702
Thomas Wood
b. 10 Aug 1658 d. 1 Dec 1702
8
Mary Wood
[1.2.6.3.1.1.1.1]
b. 29 Aug 1684 d. 12 Dec 1774
Daniel Pearson
b. 25 Dec 1684 d. 8 Jun 1759
9
Simon Pearson
[1.2.6.3.1.1.1.1.1]
b. 7 Nov 1709
Ruth Taylor
b. 3 Apr 1712
10
Ruth Pearson
[1.2.6.3.1.1.1.1.1.1]
b. 21 Oct 1739
10
Benjamin Person
[1.2.6.3.1.1.1.1.1.2]
b. 21 May 1742
10
Ezra Pearson
[1.2.6.3.1.1.1.1.1.3]
b. 16 Apr 1744 d. 30 Dec 1800
Anne Fuller
b. 1741 d. Aft 1810
11
Lucinda Pearson
[1.2.6.3.1.1.1.1.1.3.1]
b. 29 Jan 1767
+
Ezekiel Barton
b. Abt 1767
11
Lieutenant Adin Pearson
[1.2.6.3.1.1.1.1.1.3.2]
b. 28 Nov 1768 d. 7 Jun 1853
Eunice Brooks
b. 3 Oct 1771 d. 24 Nov 1801
12
Lucina Pearson
[1.2.6.3.1.1.1.1.1.3.2.1]
b. 16 Jul 1789 d. 6 Sep 1878 [
=>
]
12
Warren Pearson
[1.2.6.3.1.1.1.1.1.3.2.2]
b. 23 Jul 1792
12
Loren Pearson
[1.2.6.3.1.1.1.1.1.3.2.3]
b. 5 Oct 1797 d. 19 Jul 1861
11
Zelotes Pearson
[1.2.6.3.1.1.1.1.1.3.3]
b. 9 Sep 1771
+
Anna
b. Abt 1771
11
Clarice Pearson
[1.2.6.3.1.1.1.1.1.3.4]
b. 11 Feb 1774
+
John Little
b. Abt 1774
11
Jerusha Pearson
[1.2.6.3.1.1.1.1.1.3.5]
b. 15 Aug 1776 d. 9 Feb 1874
+
Gates Willey
b. Abt 1776
11
Anna Pearson
[1.2.6.3.1.1.1.1.1.3.6]
b. 2 Feb 1779 d. 26 Jan 1830
Elam Wright
b. 1 Dec 1774 d. 6 Feb 1831
12
Elam G Wright
[1.2.6.3.1.1.1.1.1.3.6.1]
b. 10 Feb 1811
12
Alvira Lucretia Wright
[1.2.6.3.1.1.1.1.1.3.6.2]
b. 17 Aug 1815
12
Vienna Wright
[1.2.6.3.1.1.1.1.1.3.6.3]
b. 28 Oct 1817 d. 29 Nov 1909
9
Ephraim Pearson
[1.2.6.3.1.1.1.1.2]
c. 25 Nov 1711
James Dickinson
b. 30 Jun 1678 d. 5 Jan 1705
9
Mary Dickinson
[1.2.6.3.1.1.1.1.3]
b. 29 Nov 1703 d. 8 Jun 1759
9
James Dickinson
[1.2.6.3.1.1.1.1.4]
b. 31 Dec 1705 d. 27 Jun 1756
Ruth Hartshorn
b. 12 May 1706 d. Aft 1750
10
Mary Dickinson
[1.2.6.3.1.1.1.1.4.1]
b. 20 Feb 1728
10
Submit Dickinson
[1.2.6.3.1.1.1.1.4.2]
b. 29 Jun 1731 d. 1788
10
Ruth Dickson
[1.2.6.3.1.1.1.1.4.3]
b. 3 Mar 1734
10
James Dickinson
[1.2.6.3.1.1.1.1.4.4]
b. 1 Aug 1736 d. Aft 1775
10
Jonathan Dickinson
[1.2.6.3.1.1.1.1.4.5]
b. 18 Nov 1738 d. 16 Oct 1762
Abigail Whipple
b. 30 Jan 1729 d. 21 Apr 1806
11
Mary Dickinson
[1.2.6.3.1.1.1.1.4.5.1]
b. 25 Dec 1758 d. 5 Mar 1759
11
Jonathan Dickinson
[1.2.6.3.1.1.1.1.4.5.2]
b. 30 Sep 1760
11
Mary Dickinson
[1.2.6.3.1.1.1.1.4.5.3]
b. Mar 1762 d. May 1850
10
Noah Dickinson
[1.2.6.3.1.1.1.1.4.6]
b. 14 Mar 1741 d. 16 Jan 1828
10
Mathew Dickinson
[1.2.6.3.1.1.1.1.4.7]
b. 14 Apr 1743 d. 21 Sep 1762
10
Ruth Dickinson
[1.2.6.3.1.1.1.1.4.8]
b. 29 Jul 1745 d. 22 Nov 1834
10
Love Dickinson
[1.2.6.3.1.1.1.1.4.9]
b. 2 Jun 1750
8
Thomas Wood
[1.2.6.3.1.1.1.2]
b. 18 Sep 1686 d. 27 Sep 1760
Abigail Hartshorn
b. 29 Sep 1686 d. 22 Sep 1760
9
Thomas Wood
[1.2.6.3.1.1.1.2.1]
b. 5 Feb 1711 d. 1777
Mary Lashley
b. 25 Mar 1711 d. Abt Dec 1809
10
John Wood
[1.2.6.3.1.1.1.2.1.1]
b. 13 Sep 1733
10
Elizabeth Wood
[1.2.6.3.1.1.1.2.1.2]
b. 20 Jul 1735 d. 1795
10
Johannah Wood
[1.2.6.3.1.1.1.2.1.3]
b. 22 Jun 1737 d. 3 Jun 1805
10
Alice Wood
[1.2.6.3.1.1.1.2.1.4]
b. 1738
10
Elijah Wood
[1.2.6.3.1.1.1.2.1.5]
b. 1739 d. Feb 1805
10
Lashley Levi Wood
[1.2.6.3.1.1.1.2.1.6]
b. 1740 d. 15 Aug 1809
Mary Mersey Lucas
b. Jan 1740 d. 1809
11
Mary Wood
[1.2.6.3.1.1.1.2.1.6.1]
c. 8 Apr 1764 d. 1840
John W Ogden
b. 1763 d. Apr 1824
12
Sarah Ogden
[1.2.6.3.1.1.1.2.1.6.1.1]
b. 1784
12
John W Ogden
[1.2.6.3.1.1.1.2.1.6.1.2]
b. 1786 d. 1830
12
Joseph Ogden
[1.2.6.3.1.1.1.2.1.6.1.3]
b. 1788 d. 1 Nov 1854
12
Otho W Ogden
[1.2.6.3.1.1.1.2.1.6.1.4]
b. 1792 d. 5 Apr 1816 [
=>
]
12
James Ogden
[1.2.6.3.1.1.1.2.1.6.1.5]
b. 29 Nov 1792 d. 24 Aug 1852
12
Thomas Ogden
[1.2.6.3.1.1.1.2.1.6.1.6]
b. Abt 1796 d. Bef 25 Jul 1845
12
Elias Ogden
[1.2.6.3.1.1.1.2.1.6.1.7]
b. 1798 d. 1847
12
Polly Ogden
[1.2.6.3.1.1.1.2.1.6.1.8]
b. 1800
11
Leatha Ann Wood
[1.2.6.3.1.1.1.2.1.6.2]
b. 10 Aug 1766 d. 1831
11
John Wood
[1.2.6.3.1.1.1.2.1.6.3]
b. 10 Aug 1768 d. 15 Sep 1853
11
Basil Wood
[1.2.6.3.1.1.1.2.1.6.4]
b. 1770 d. 20 Jul 1841
11
Casey Wood
[1.2.6.3.1.1.1.2.1.6.5]
b. 1772
11
Elizabeth Wood
[1.2.6.3.1.1.1.2.1.6.6]
b. 1780
11
Thomas Wood
[1.2.6.3.1.1.1.2.1.6.7]
b. 1782 d. 1820
10
Thomas Wood
[1.2.6.3.1.1.1.2.1.7]
b. 1740
10
Robert Wood
[1.2.6.3.1.1.1.2.1.8]
b. 1741
9
Mary Wood
[1.2.6.3.1.1.1.2.2]
b. 3 Nov 1712 d. 1 Aug 1727
9
John Wood
[1.2.6.3.1.1.1.2.3]
b. 4 Apr 1715 d. 11 Aug 1775
9
Ruth Wood
[1.2.6.3.1.1.1.2.4]
b. 24 Oct 1718
9
Martha Wood
[1.2.6.3.1.1.1.2.5]
b. 17 Feb 1722
9
Ephraim Wood
[1.2.6.3.1.1.1.2.6]
b. 18 Jun 1723 d. 1746
9
Dinah Wood
[1.2.6.3.1.1.1.2.7]
b. 17 Jun 1725
9
Nehemiah Wood
[1.2.6.3.1.1.1.2.8]
b. 16 Jan 1727 d. 1796
9
Jonathan Wood
[1.2.6.3.1.1.1.2.9]
b. 16 May 1730
8
Nehemiah Wood
[1.2.6.3.1.1.1.3]
b. 14 Jul 1688 d. 4 Aug 1688
8
Ephraim Wood
[1.2.6.3.1.1.1.4]
b. 13 Oct 1689 d. 26 Jun 1713
8
Samuel Wood
[1.2.6.3.1.1.1.5]
b. 31 May 1692 d. 25 Jul 1742
+
Jane Dudley
c. 1693
8
Elizabeth Wood
[1.2.6.3.1.1.1.6]
b. 8 Apr 1694 d. 23 Jul 1731
+
Philip Turner
8
Mehitable Wood
[1.2.6.3.1.1.1.7]
b. 18 Dec 1695 d. 26 Oct 1758
James Hall
b. 1693 d. 16 Jan 1742
9
Mary Hall
[1.2.6.3.1.1.1.7.1]
b. 27 Sep 1717 d. 1778
9
James Hall
[1.2.6.3.1.1.1.7.2]
b. 20 Apr 1720 d. 2 Feb 1807
9
Mehetable Hall
[1.2.6.3.1.1.1.7.3]
b. 18 Feb 1722 d. 7 Dec 1803
9
Elizabeth Hall
[1.2.6.3.1.1.1.7.4]
b. 18 Apr 1723
9
Jane Hall
[1.2.6.3.1.1.1.7.5]
b. 5 Mar 1725
9
William Hall
[1.2.6.3.1.1.1.7.6]
b. 12 Jul 1728
9
Thomas Hall
[1.2.6.3.1.1.1.7.7]
b. 14 Jun 1730
9
Ephraim Hall
[1.2.6.3.1.1.1.7.8]
b. 21 Sep 1732 d. 29 Sep 1816
9
Gershom Hall
[1.2.6.3.1.1.1.7.9]
b. 25 Feb 1735
9
Josiah Hall
[1.2.6.3.1.1.1.7.10]
b. 27 Mar 1738 d. 1810
8
Ann Wood
[1.2.6.3.1.1.1.8]
b. 11 Apr 1700 d. 30 Jul 1793
Isaac Sargent
b. Abt 24 Feb 1695 d. 12 Apr 1742
9
John Sargent
[1.2.6.3.1.1.1.8.1]
b. 6 Mar 1722 d. Dec 1827
9
Mary Sargent
[1.2.6.3.1.1.1.8.2]
b. 22 Apr 1725 d. 12 Dec 1740
9
Ana Sargent
[1.2.6.3.1.1.1.8.3]
b. 23 Feb 1727 d. 8 May 1821
9
Isaac Sargent
[1.2.6.3.1.1.1.8.4]
b. 30 Dec 1728 d. 17 Dec 1729
9
Hannah Sargent
[1.2.6.3.1.1.1.8.5]
b. 3 Dec 1730 d. 14 Aug 1751
9
Ruth Sargent
[1.2.6.3.1.1.1.8.6]
b. 14 Oct 1732 d. 29 Aug 1808
9
Elizabeth Sargent
[1.2.6.3.1.1.1.8.7]
b. 5 Feb 1734 d. 28 Dec 1776
9
Deborah Sargent
[1.2.6.3.1.1.1.8.8]
b. 2 Feb 1736 d. 1833
9
Isaac Sargent
[1.2.6.3.1.1.1.8.9]
b. 8 Dec 1737 d. Jan 1813
8
Hannah Wood
[1.2.6.3.1.1.1.9]
b. 21 May 1703 d. 18 Mar 1764
7
John Hunt
[1.2.6.3.1.1.2]
b. 1667 d. 10 Jun 1669
7
Nehemiah Hunt
[1.2.6.3.1.1.3]
b. 29 Sep 1669 d. 27 Oct 1718
7
John Hunt
[1.2.6.3.1.1.4]
b. 12 Jan 1673 d. 26 Dec 1751
7
William Hunt
[1.2.6.3.1.1.5]
b. 1 Nov 1678 d. 12 May 1755
7
Mercy Hunt
[1.2.6.3.1.1.6]
b. 29 Nov 1676 d. 28 Nov 1733
7
Hannah Hunt
[1.2.6.3.1.1.7]
b. 24 Jan 1681 d. 2 Aug 1736
7
Simon Hunt
[1.2.6.3.1.1.8]
b. 7 Mar 1682 d. 7 Oct 1702
7
Rebecca Hunt
[1.2.6.3.1.1.9]
b. 1686 d. 28 Nov 1733
7
Elizabeth Hunt
[1.2.6.3.1.1.10]
b. 3 Jun 1687 d. 13 Jul 1767
6
Samuel Hunt
[1.2.6.3.1.2]
b. 1633 d. 1707
Elizabeth Redding
b. 1634 d. 16 Feb 1706
7
Samuel Hunt
[1.2.6.3.1.2.1]
b. 17 Nov 1657 d. 11 Jan 1742
Ruth Todd
b. 11 Feb 1657 d. 18 Feb 1716
8
Samuel Hunt
[1.2.6.3.1.2.1.1]
b. 4 Feb 1678 d. 13 Oct 1738
Sarah Stearns
b. 21 Mar 1681 d. 10 Sep 1708
9
Sarah Hunt
[1.2.6.3.1.2.1.1.1]
b. 22 Oct 1702 d. 26 Jan 1750
9
Mary Hunt
[1.2.6.3.1.2.1.1.2]
b. 12 Jan 1705 d. 11 May 1796
Anne Haseltine
b. 4 Aug 1677 d. 16 Jul 1757
9
Thomas Hunt
[1.2.6.3.1.2.1.1.3]
b. 2 Aug 1710 d. Nov 1710
9
Samuel Hunt
[1.2.6.3.1.2.1.1.4]
b. 26 Sep 1711 d. Jan 1806
Hannah Kimball
b. 14 Apr 1723 d. 25 May 1776
10
Samuel Hunt
[1.2.6.3.1.2.1.1.4.1]
b. 19 Dec 1741 d. 1 Apr 1742
10
Samuel Hunt
[1.2.6.3.1.2.1.1.4.2]
b. 20 Sep 1743 d. 29 Apr 1766
10
Hannah Hunt
[1.2.6.3.1.2.1.1.4.3]
b. 3 Jan 1746 d. 9 Dec 1749
10
Johathan Hunt
[1.2.6.3.1.2.1.1.4.4]
b. 2 Jul 1750
10
Martha Hunt
[1.2.6.3.1.2.1.1.4.5]
b. 2 Apr 1758 d. 15 Feb 1825
10
Ebenezer Hunt
[1.2.6.3.1.2.1.1.4.6]
b. 18 Apr 1760 d. 30 Sep 1776
10
Perley Hunt
[1.2.6.3.1.2.1.1.4.7]
b. 23 Nov 1762 d. 21 Jun 1828
Persis Gleason
b. Sep 1766 d. 27 May 1835
11
Ebenezer
[1.2.6.3.1.2.1.1.4.7.1]
b. 23 Jun 1785 d. 24 Nov 1817
11
Elijah Hunt
[1.2.6.3.1.2.1.1.4.7.2]
b. 25 Apr 1787 d. 7 Sep 1860
Amanda Marsh
b. 14 Jul 1791 d. Aft 1850
12
Jason Hunt
[1.2.6.3.1.2.1.1.4.7.2.1]
b. 25 Apr 1811 d. 21 Oct 1888
12
Elijah Hunt, Jr
[1.2.6.3.1.2.1.1.4.7.2.2]
b. 1818
12
Ebenezer T Hunt
[1.2.6.3.1.2.1.1.4.7.2.3]
b. 1820 d. 24 Jul 1898
12
Jane Hunt
[1.2.6.3.1.2.1.1.4.7.2.4]
b. 1824
12
Samuel Russell Hunt
[1.2.6.3.1.2.1.1.4.7.2.5]
b. 22 Oct 1827 d. 14 May 1912 [
=>
]
12
Jackson Hunt
[1.2.6.3.1.2.1.1.4.7.2.6]
b. 1834
11
Anna Hunt
[1.2.6.3.1.2.1.1.4.7.3]
b. 15 Feb 1788 d. 18 Dec 1791
11
Persis Hunt
[1.2.6.3.1.2.1.1.4.7.4]
b. 20 May 1790
11
Amy Hunt
[1.2.6.3.1.2.1.1.4.7.5]
b. 1 Jul 1793 d. 26 Jul 1793
11
Perley Hunt
[1.2.6.3.1.2.1.1.4.7.6]
b. 5 Nov 1795 d. 18 Nov 1863
11
Kimball Hunt
[1.2.6.3.1.2.1.1.4.7.7]
b. 18 Feb 1797 d. Oct 1821
11
Anna Hunt
[1.2.6.3.1.2.1.1.4.7.8]
b. 20 Jun 1800
11
Samuel Hunt
[1.2.6.3.1.2.1.1.4.7.9]
b. 14 Jan 1803 d. 30 Sep 1846
11
Gratia Hunt
[1.2.6.3.1.2.1.1.4.7.10]
b. 25 Jun 1805 d. 20 Nov 1872
11
Charles Dickenson Hunt
[1.2.6.3.1.2.1.1.4.7.11]
b. 31 Jul 1807 d. Aft 1855
11
Fidelia Hunt
[1.2.6.3.1.2.1.1.4.7.12]
b. 1 Oct 1809 d. 25 Jan 1826
10
David Hunt
[1.2.6.3.1.2.1.1.4.8]
b. 3 Jun 1767 d. 4 Feb 1850
9
Ann Hunt
[1.2.6.3.1.2.1.1.5]
b. 8 Apr 1714 d. 1740
9
Mehitable Hunt
[1.2.6.3.1.2.1.1.6]
b. 9 Jul 1716 d. 3 Mar 1807
9
Susanna Hunt
[1.2.6.3.1.2.1.1.7]
b. 21 Feb 1717
9
David Hunt
[1.2.6.3.1.2.1.1.8]
b. 19 Nov 1719
9
Jonathan Hunt
[1.2.6.3.1.2.1.1.9]
b. 25 Feb 1722
8
John Hunt
[1.2.6.3.1.2.1.2]
b. 30 Dec 1680 d. 22 Jan 1740
8
Elizabeth Hunt
[1.2.6.3.1.2.1.3]
b. 4 Mar 1682 d. 13 Jul 1685
7
Elisabeth Hunt
[1.2.6.3.1.2.2]
b. 29 May 1661 d. 9 Jul 1689
Francis Palmer
b. 4 Dec 1657 d. 19 Apr 1733
8
Elizabeth Palmer
[1.2.6.3.1.2.2.1]
b. 20 Dec 1684 d. 17 Aug 1705
8
John Palmer
[1.2.6.3.1.2.2.2]
b. 21 Jun 1689 d. 20 May 1761
Mary Stickney
b. 1 Mar 1687 d. 2 Nov 1763
9
Elizabeth Palmer
[1.2.6.3.1.2.2.2.1]
b. 1 May 1710 d. 10 Jun 1782
9
Daniel Palmer
[1.2.6.3.1.2.2.2.2]
b. 31 Jul 1712 d. 1776
9
Jane Palmer
[1.2.6.3.1.2.2.2.3]
b. 24 Dec 1714 d. 2 Sep 1793
9
Mary Palmer
[1.2.6.3.1.2.2.2.4]
b. 1 Jun 1717 d. 2 Nov 1763
Moses Duty
b. 2 Sep 1700 d. 29 Dec 1763
10
Moses Duty
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.1]
b. 9 Aug 1742 d. 27 May 1836
Ann Holland
b. 13 Dec 1730 d. 24 Jan 1782
11
Mehitabel Duty
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.1.1]
b. 18 Jul 1762 d. 22 Mar 1826
11
Susa Duty
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.1.2]
b. 9 Apr 1769
10
Mary Elizabeth Duty
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2]
b. 11 Oct 1743 d. 27 May 1836
Asael Smith
b. 7 Mar 1744 d. 31 Oct 1830
11
Jesse Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.1]
b. 20 Apr 1768 d. 16 Mar 1793
Hannah Peabody
b. 1771 d. 28 Sep 1849
12
Benjamin Peabody Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.1.1]
b. 2 May 1793 d. 15 Jan 1850 [
=>
]
12
Eliza Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.1.2]
b. 9 Mar 1795 d. 22 Jul 1870 [
=>
]
12
Ira Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.1.3]
b. 30 Jan 1797 d. 5 Mar 1874 [
=>
]
12
Harvey Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.1.4]
b. 1 Apr 1799 d. 20 Feb 1872 [
=>
]
12
Harriet Tupper Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.1.5]
b. 8 Apr 1801 d. Apr 1879
12
Stephen Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.1.6]
b. 2 May 1803 d. 16 Apr 1851
12
Mary Polly Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.1.7]
b. 4 May 1805 d. 13 Jun 1870
12
Catherine Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.1.8]
b. 13 Jul 1807 d. 2 May 1888 [
=>
]
12
Royal Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.1.9]
b. 2 Jul 1809 d. 1882
12
Sarah B Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.1.10]
b. 16 Dec 1810 d. 2 Oct 1887
+
Christene Smith
11
Priscilla Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.2]
b. 21 Oct 1769 d. 17 Apr 1860
John Curtis Waller
12
Calvin C. Waller
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.2.1]
b. 6 Jun 1797 d. Jun 1864
12
Dolly Waller
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.2.2]
b. 16 Oct 1799 d. 20 Jun 1800
12
Marshall Waller
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.2.3]
b. 18 Mar 1801
12
Royal H Waller
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.2.4]
b. 29 Nov 1802 d. 29 Sep 1866
12
Dudley C Waller
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.2.5]
b. 29 Sep 1804 d. Abt 1868
12
Bushrod W Waller
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.2.6]
b. 18 Oct 1806
12
Silas Waller
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.2.7]
b. 1 Jan 1809 d. 2 Jun 1866 [
=>
]
12
Salley P Waller
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.2.8]
b. 31 Oct 1810 d. 15 Aug 1874
12
John J Waller
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.2.9]
b. 9 Sep 1812 d. 5 Nov 1812
+
Michael Smith
11
Joseph Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.3]
b. 12 Jul 1771 d. 14 Sep 1840
Lucy Mack
b. 8 Jul 1775 d. 14 May 1856
12
Son Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.3.1]
b. 1797 d. 1797
12
Daughter Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.3.2]
b. 1797 d. 1797
12
Alvin Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.3.3]
b. 11 Feb 1798 d. 19 Nov 1823
12
Hyrum Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.3.4]
b. 9 Feb 1800 d. 27 Jun 1844 [
=>
]
12
Sophronia Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.3.5]
b. 17 May 1803 d. 28 Oct 1876 [
=>
]
12
Samuel Harrison Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.3.6]
b. 13 Mar 1808 d. 30 Jul 1844 [
=>
]
12
Ephraim Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.3.7]
b. 13 Mar 1810 d. 24 Mar 1810
12
William B Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.3.8]
b. 13 Mar 1811 d. 13 Nov 1893 [
=>
]
12
Katherine Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.3.9]
b. 28 Jul 1813 d. 1 Feb 1900 [
=>
]
12
Don Carlos Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.3.10]
b. 25 Mar 1816 d. 7 Aug 1841 [
=>
]
12
Lucy Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.3.11]
b. 18 Jul 1821 d. 9 Dec 1882 [
=>
]
12
Joseph Smith, Jr
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.3.12]
b. 23 Dec 1805 d. 27 Jun 1844 [
=>
]
11
Asahel Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.4]
b. 21 May 1773 d. 21 Jul 1848
Elizabeth Shellenger
b. 1 Dec 1785 d. 14 Oct 1846
12
Elias Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.4.1]
b. 6 Sep 1804 d. 24 Jun 1888 [
=>
]
12
Emily Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.4.2]
b. 1 Sep 1806 d. 11 Aug 1893 [
=>
]
12
Jessie Johnson Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.4.3]
b. 6 Oct 1808 d. 1 Jul 1834 [
=>
]
12
Esther Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.4.4]
b. 20 Sep 1810 d. 31 Oct 1856 [
=>
]
12
Mary Jane Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.4.5]
b. 29 Apr 1815 d. 1 Mar 1878 [
=>
]
12
Julia Priscilla Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.4.6]
b. 4 Mar 1815 d. 14 Aug 1906 [
=>
]
12
Silas Schellinger Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.4.7]
b. 6 Jun 1822 d. 11 Jun 1892 [
=>
]
12
Martha Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.4.8]
b. 9 Jun 1817 d. 12 Oct 1902 [
=>
]
+
Jane Smith
b. 1775
11
Mary Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.5]
b. 4 Jun 1775 d. 24 May 1844
Isaac Pierce
b. 11 Oct 1773 d. 9 Nov 1847
12
Eunice Pierce
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.5.1]
b. 29 Apr 1799 d. 9 Jun 1803
12
Laura Pierce
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.5.2]
b. 12 Nov 1801 d. 1803
12
Miranda Pierce
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.5.3]
b. 17 Jun 1803 d. 16 Sep 1831
12
Horace Pierce
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.5.4]
b. 8 Jun 1805 d. 20 May 1877
12
John S. Pierce
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.5.5]
b. 6 Jun 1807 d. 3 Apr 1854
12
Susan Pierce
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.5.6]
b. 20 Jun 1809 d. 4 Apr 1855
12
Mary Pierce
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.5.7]
b. 25 Apr 1811
12
Elisabeth Ann Pierce
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.5.8]
b. 2 Sep 1817 d. 16 May 1855
+
Joseph Brimhall
b. 1771
+
Charles Smith
b. 1772
11
Samuel Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.6]
b. 15 Sep 1777 d. 1 Apr 1830
Frances Wilcox
b. 1780
12
Charles Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.6.1]
b. 16 Apr 1817
12
Laura Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.6.2]
b. 1 Mar 1819
12
Horace Jay Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.6.3]
b. 12 Jul 1821
12
Sarah Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.6.4]
b. 11 Jun 1824
12
Elizabeth Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.6.5]
b. 16 Jul 1826
11
Silas Sanford Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.7]
b. 1 Oct 1779 d. 13 Sep 1839
Ruth Steven
b. 1782 d. 10 Jan 1864
12
Charles Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.7.1]
b. 11 Nov 1806 d. 7 May 1809
12
Charity Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.7.2]
b. 1 Apr 1808 d. 2 Jun 1888
12
Curtis Stevens Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.7.3]
b. 29 Oct 1809 d. 23 Sep 1861 [
=>
]
12
Samuel Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.7.4]
b. 3 Oct 1811 d. 7 Mar 1826
12
Stephen Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.7.5]
b. 8 Jan 1815 d. 20 Feb 1891
12
Susan Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.7.6]
b. 19 Oct 1817 d. 20 Nov 1846
12
Asahel Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.7.7]
b. 12 Oct 1819 d. 15 May 1834
Mary Aikens
b. 13 Aug 1797 d. 27 Apr 1877
12
Silas Sanford Smith, Jr
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.7.8]
b. 26 Oct 1830 d. 11 Oct 1910 [
=>
]
12
John Aikens Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.7.9]
b. 6 Jul 1832 d. 27 Nov 1838
12
Jesse Nathaniel Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.7.10]
b. 2 Dec 1834 d. 5 Jun 1906 [
=>
]
11
Patriarch John Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.8]
b. 16 Jul 1781 d. 23 May 1854
Clarissa Loomis Lyman
b. 27 Jun 1790 d. 14 Feb 1854
12
Daughter Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.8.1]
b. 9 May 1816 d. 9 May 1816
12
George Albert Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.8.2]
b. 26 Jun 1817 d. 1 Sep 1875 [
=>
]
12
Caroline Clara Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.8.3]
b. 6 Jun 1820 d. 8 Jan 1895 [
=>
]
12
John Lyman Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.8.4]
b. 17 Nov 1828 d. 21 Feb 1898
11
Susannah Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.9]
b. 18 May 1783 d. 22 Mar 1849
+
John Hall
11
Stephen Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.10]
b. 23 Apr 1785 d. 25 Jul 1802
+
Sally Hadley
11
Sarah Smith
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.11]
b. 16 May 1789 d. 27 May 1824
Joseph Sanford
b. 1785 d. 11 Sep 1825
12
Martin Sanford
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.11.1]
b. 24 Sep 1811 d. 24 Nov 1817
12
Martin Sanford
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.11.2]
b. 4 Nov 1812 d. 3 Dec 1820
12
Joseph Sanford
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.11.3]
b. 1813 d. 1816
12
Charlette Sanford
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.11.4]
b. 4 Mar 1814 d. Abt 1858
12
William Wallace Sanford
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.11.5]
b. 13 Jun 1816 d. 1844
12
John Lyman Sanford
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.11.6]
b. 20 May 1818
10
Eunice Duty
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.3]
b. 20 Jun 1745 d. 27 May 1836
10
Mark Duty
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.4]
b. 16 Oct 1747 d. 27 May 1836
Abigail Woodberry
b. 1 Apr 1746 d. 1774
11
Andrew Woodbarry Duty
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.4.1]
b. 18 Jul 1772 d. 1823
11
Hannah Duty
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.4.2]
b. 14 Dec 1773
11
Mark Duty
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.4.3]
b. 16 Jun 1779 d. Abt 1855
11
Ebenezer Duty
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.4.4]
b. 2 Jun 1782 d. 7 Sep 1852
10
William Duty
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.5]
b. 9 Jan 1749 d. 27 Sep 1812
Mary Rowell
b. 29 Apr 1750 d. 27 May 1836
11
Mary Duty
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.5.1]
b. 7 Nov 1774
11
Phebe Dutey
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.5.2]
b. 4 Apr 1778 d. 16 Apr 1852
11
Abagail Duty
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.5.3]
b. 4 Dec 1779
11
William Duty
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.5.4]
b. 4 Jun 1781
11
Hannah Duty
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.5.5]
b. 13 May 1783 d. Oct 1787
11
Charles Carpenter Duty
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.5.6]
b. 12 Feb 1785
11
Benjamin Rowell Duty
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.5.7]
b. 15 Aug 1787
11
Nathaniel Peabody Duty
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.5.8]
b. 11 Aug 1789
10
Elizabeth Duty
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.6]
b. 26 Oct 1751
10
Sarah Duty
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.7]
b. 25 Jul 1753 d. 21 Dec 1767
10
Hannah Duty
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.8]
b. 11 Jun 1755 d. 27 May 1836
William Rowell
b. 1749 d. 30 Mar 1844
11
Sarah Rowell
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.8.1]
b. 4 Jul 1777
11
Moses Duty Rowell
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.8.2]
b. 5 Oct 1778 d. 16 Nov 1857
11
John Sullivan Rowell
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.8.3]
b. 1779 d. Abt 1824
11
Lavina Rowell
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.8.4]
b. 1782 d. 11 Jan 1877
11
Elsie Alice Rowell
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.8.5]
b. Abt 1786
11
Caleb Rowell
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.8.6]
b. Abt 1788 d. 5 Apr 1835
11
Isaiah Rowell
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.8.7]
b. Abt 1792 d. 25 Jun 1847
11
George Rowell
[1.2.6.3.1.2.2.2.4.8.8]
b. 16 Oct 1794 d. 21 Jan 1873
9
Hannah Palmer
[1.2.6.3.1.2.2.2.5]
b. 30 Sep 1719 d. 9 Mar 1792
Gideon Walker
b. 1715
10
Temperance Walker
[1.2.6.3.1.2.2.2.5.1]
b. Abt 1739
10
Eliphalet Walker
[1.2.6.3.1.2.2.2.5.2]
b. 3 Sep 1747 d. 28 Mar 1824
10
Mehitable Walker
[1.2.6.3.1.2.2.2.5.3]
b. Abt 1749
9
Mehitable Palmer
[1.2.6.3.1.2.2.2.6]
b. 18 Mar 1727 d. Bef Nov 1763
9
John Palmer
[1.2.6.3.1.2.2.2.7]
b. 30 Nov 1729 d. 6 Jan 1807
7
William Hunt
[1.2.6.3.1.2.3]
b. 23 Apr 1663 d. 12 Dec 1747
7
Joseph Hunt
[1.2.6.3.1.2.4]
b. 28 Oct 1665 d. 1757
7
Peter Hunt
[1.2.6.3.1.2.5]
b. 8 Aug 1668 d. 8 Mar 1669
6
Elizabeth Hunt
[1.2.6.3.1.3]
b. 1 Apr 1634 d. 18 Aug 1704
John Barron
b. 1635 d. 1 Jan 1693
7
Isaac Barron
[1.2.6.3.1.3.1]
b. Abt 1664
7
John Barron
[1.2.6.3.1.3.2]
b. 4 Apr 1665
7
Elizabeth Barron
[1.2.6.3.1.3.3]
b. 28 Sep 1667
7
Moses Barron
[1.2.6.3.1.3.4]
b. 26 Mar 1669 d. 1742
7
Elias Barron
[1.2.6.3.1.3.5]
b. 14 Jun 1672 d. 1725
7
Dorothy Barron
[1.2.6.3.1.3.6]
b. 6 Mar 1675
6
Ann Hunt
[1.2.6.3.1.4]
b. 17 May 1635 d. 29 Dec 1714
Thomas Wood
b. 7 Apr 1633 d. 21 Jul 1687
7
Mary Wood
[1.2.6.3.1.4.1]
b. 15 Mar 1654
James Chute
b. 1649 d. 1730
8
Mary Chute
[1.2.6.3.1.4.1.1]
b. 16 Sep 1674 d. 10 Sep 1750
8
Elisabeth Chute
[1.2.6.3.1.4.1.2]
b. 22 Jun 1676 d. 3 Apr 1761
8
Ann Chute
[1.2.6.3.1.4.1.3]
b. 9 Oct 1679 d. 1726
8
Lionel Chute
[1.2.6.3.1.4.1.4]
b. 15 Apr 1681 d. Aft 30 Apr 1730
8
James Chute
[1.2.6.3.1.4.1.5]
b. 14 Jun 1686 d. 31 Jan 1769
8
Thomas Chute
[1.2.6.3.1.4.1.6]
b. 30 Jan 1690 d. 1770
8
Martha Chute
[1.2.6.3.1.4.1.7]
b. 15 Feb 1693 d. 4 Jul 1777
8
Ruth Chute
[1.2.6.3.1.4.1.8]
b. 2 Nov 1695 d. 30 Apr 1776
8
Hannah Chute
[1.2.6.3.1.4.1.9]
b. 8 Jul 1700 d. 1787
7
John Wood
[1.2.6.3.1.4.2]
b. 2 Mar 1656 d. 24 Jun 1735
Isabella Hazen
b. 21 May 1662 d. 24 Jul 1735
8
Hannah Wood
[1.2.6.3.1.4.2.1]
b. 12 Jan 1681 d. 3 Mar 1733
8
John Wood
[1.2.6.3.1.4.2.2]
b. 13 Feb 1683 d. 13 Feb 1735
8
Priscillia Wood
[1.2.6.3.1.4.2.3]
b. 27 Aug 1686 d. 22 May 1721
8
Edward Wood
[1.2.6.3.1.4.2.4]
b. 7 Sep 1689 d. Bef 1704
8
Thomas Wood
[1.2.6.3.1.4.2.5]
b. 28 Nov 1691 d. 1764
8
Samuel Wood
[1.2.6.3.1.4.2.6]
b. 31 May 1692 d. 25 Jul 1742
8
Joseph Wood
[1.2.6.3.1.4.2.7]
b. 5 May 1696 d. 7 Feb 1766
8
Ebenezer Wood
[1.2.6.3.1.4.2.8]
b. 18 Sep 1698 d. 18 Jul 1744
8
Abigail Annie Wood
[1.2.6.3.1.4.2.9]
b. 17 Dec 1700 d. 4 Apr 1776
8
Richard Wood
[1.2.6.3.1.4.2.10]
b. 30 Jan 1706 d. 3 Jul 1761
8
Josiah Wood
[1.2.6.3.1.4.2.11]
b. 5 Apr 1708 d. Nov 1767
7
Thomas Wood
[1.2.6.3.1.4.3]
b. 10 Aug 1658 d. 1 Dec 1702
Mary Hunt
b. 28 Sep 1664 d. 1 Dec 1702
8
Mary Wood
[1.2.6.3.1.4.3.1]
b. 29 Aug 1684 d. 12 Dec 1774
Daniel Pearson
b. 25 Dec 1684 d. 8 Jun 1759
9
Simon Pearson
[1.2.6.3.1.4.3.1.1]
b. 7 Nov 1709
Ruth Taylor
b. 3 Apr 1712
10
Ruth Pearson
[1.2.6.3.1.4.3.1.1.1]
b. 21 Oct 1739
10
Benjamin Person
[1.2.6.3.1.4.3.1.1.2]
b. 21 May 1742
10
Ezra Pearson
[1.2.6.3.1.4.3.1.1.3]
b. 16 Apr 1744 d. 30 Dec 1800
Anne Fuller
b. 1741 d. Aft 1810
11
Lucinda Pearson
[1.2.6.3.1.4.3.1.1.3.1]
b. 29 Jan 1767
+
Ezekiel Barton
b. Abt 1767
11
Lieutenant Adin Pearson
[1.2.6.3.1.4.3.1.1.3.2]
b. 28 Nov 1768 d. 7 Jun 1853
Eunice Brooks
b. 3 Oct 1771 d. 24 Nov 1801
12
Lucina Pearson
[1.2.6.3.1.4.3.1.1.3.2.1]
b. 16 Jul 1789 d. 6 Sep 1878 [
=>
]
12
Warren Pearson
[1.2.6.3.1.4.3.1.1.3.2.2]
b. 23 Jul 1792
12
Loren Pearson
[1.2.6.3.1.4.3.1.1.3.2.3]
b. 5 Oct 1797 d. 19 Jul 1861
11
Zelotes Pearson
[1.2.6.3.1.4.3.1.1.3.3]
b. 9 Sep 1771
+
Anna
b. Abt 1771
11
Clarice Pearson
[1.2.6.3.1.4.3.1.1.3.4]
b. 11 Feb 1774
+
John Little
b. Abt 1774
11
Jerusha Pearson
[1.2.6.3.1.4.3.1.1.3.5]
b. 15 Aug 1776 d. 9 Feb 1874
+
Gates Willey
b. Abt 1776
11
Anna Pearson
[1.2.6.3.1.4.3.1.1.3.6]
b. 2 Feb 1779 d. 26 Jan 1830
Elam Wright
b. 1 Dec 1774 d. 6 Feb 1831
12
Elam G Wright
[1.2.6.3.1.4.3.1.1.3.6.1]
b. 10 Feb 1811
12
Alvira Lucretia Wright
[1.2.6.3.1.4.3.1.1.3.6.2]
b. 17 Aug 1815
12
Vienna Wright
[1.2.6.3.1.4.3.1.1.3.6.3]
b. 28 Oct 1817 d. 29 Nov 1909
9
Ephraim Pearson
[1.2.6.3.1.4.3.1.2]
c. 25 Nov 1711
James Dickinson
b. 30 Jun 1678 d. 5 Jan 1705
9
Mary Dickinson
[1.2.6.3.1.4.3.1.3]
b. 29 Nov 1703 d. 8 Jun 1759
9
James Dickinson
[1.2.6.3.1.4.3.1.4]
b. 31 Dec 1705 d. 27 Jun 1756
Ruth Hartshorn
b. 12 May 1706 d. Aft 1750
10
Mary Dickinson
[1.2.6.3.1.4.3.1.4.1]
b. 20 Feb 1728
10
Submit Dickinson
[1.2.6.3.1.4.3.1.4.2]
b. 29 Jun 1731 d. 1788
10
Ruth Dickson
[1.2.6.3.1.4.3.1.4.3]
b. 3 Mar 1734
10
James Dickinson
[1.2.6.3.1.4.3.1.4.4]
b. 1 Aug 1736 d. Aft 1775
10
Jonathan Dickinson
[1.2.6.3.1.4.3.1.4.5]
b. 18 Nov 1738 d. 16 Oct 1762
Abigail Whipple
b. 30 Jan 1729 d. 21 Apr 1806
11
Mary Dickinson
[1.2.6.3.1.4.3.1.4.5.1]
b. 25 Dec 1758 d. 5 Mar 1759
11
Jonathan Dickinson
[1.2.6.3.1.4.3.1.4.5.2]
b. 30 Sep 1760
11
Mary Dickinson
[1.2.6.3.1.4.3.1.4.5.3]
b. Mar 1762 d. May 1850
10
Noah Dickinson
[1.2.6.3.1.4.3.1.4.6]
b. 14 Mar 1741 d. 16 Jan 1828
10
Mathew Dickinson
[1.2.6.3.1.4.3.1.4.7]
b. 14 Apr 1743 d. 21 Sep 1762
10
Ruth Dickinson
[1.2.6.3.1.4.3.1.4.8]
b. 29 Jul 1745 d. 22 Nov 1834
10
Love Dickinson
[1.2.6.3.1.4.3.1.4.9]
b. 2 Jun 1750
8
Thomas Wood
[1.2.6.3.1.4.3.2]
b. 18 Sep 1686 d. 27 Sep 1760
Abigail Hartshorn
b. 29 Sep 1686 d. 22 Sep 1760
9
Thomas Wood
[1.2.6.3.1.4.3.2.1]
b. 5 Feb 1711 d. 1777
Mary Lashley
b. 25 Mar 1711 d. Abt Dec 1809
10
John Wood
[1.2.6.3.1.4.3.2.1.1]
b. 13 Sep 1733
10
Elizabeth Wood
[1.2.6.3.1.4.3.2.1.2]
b. 20 Jul 1735 d. 1795
10
Johannah Wood
[1.2.6.3.1.4.3.2.1.3]
b. 22 Jun 1737 d. 3 Jun 1805
10
Alice Wood
[1.2.6.3.1.4.3.2.1.4]
b. 1738
10
Elijah Wood
[1.2.6.3.1.4.3.2.1.5]
b. 1739 d. Feb 1805
10
Lashley Levi Wood
[1.2.6.3.1.4.3.2.1.6]
b. 1740 d. 15 Aug 1809
Mary Mersey Lucas
b. Jan 1740 d. 1809
11
Mary Wood
[1.2.6.3.1.4.3.2.1.6.1]
c. 8 Apr 1764 d. 1840
John W Ogden
b. 1763 d. Apr 1824
12
Sarah Ogden
[1.2.6.3.1.4.3.2.1.6.1.1]
b. 1784
12
John W Ogden
[1.2.6.3.1.4.3.2.1.6.1.2]
b. 1786 d. 1830
12
Joseph Ogden
[1.2.6.3.1.4.3.2.1.6.1.3]
b. 1788 d. 1 Nov 1854
12
Otho W Ogden
[1.2.6.3.1.4.3.2.1.6.1.4]
b. 1792 d. 5 Apr 1816 [
=>
]
12
James Ogden
[1.2.6.3.1.4.3.2.1.6.1.5]
b. 29 Nov 1792 d. 24 Aug 1852
12
Thomas Ogden
[1.2.6.3.1.4.3.2.1.6.1.6]
b. Abt 1796 d. Bef 25 Jul 1845
12
Elias Ogden
[1.2.6.3.1.4.3.2.1.6.1.7]
b. 1798 d. 1847
12
Polly Ogden
[1.2.6.3.1.4.3.2.1.6.1.8]
b. 1800
11
Leatha Ann Wood
[1.2.6.3.1.4.3.2.1.6.2]
b. 10 Aug 1766 d. 1831
11
John Wood
[1.2.6.3.1.4.3.2.1.6.3]
b. 10 Aug 1768 d. 15 Sep 1853
11
Basil Wood
[1.2.6.3.1.4.3.2.1.6.4]
b. 1770 d. 20 Jul 1841
11
Casey Wood
[1.2.6.3.1.4.3.2.1.6.5]
b. 1772
11
Elizabeth Wood
[1.2.6.3.1.4.3.2.1.6.6]
b. 1780
11
Thomas Wood
[1.2.6.3.1.4.3.2.1.6.7]
b. 1782 d. 1820
10
Thomas Wood
[1.2.6.3.1.4.3.2.1.7]
b. 1740
10
Robert Wood
[1.2.6.3.1.4.3.2.1.8]
b. 1741
9
Mary Wood
[1.2.6.3.1.4.3.2.2]
b. 3 Nov 1712 d. 1 Aug 1727
9
John Wood
[1.2.6.3.1.4.3.2.3]
b. 4 Apr 1715 d. 11 Aug 1775
9
Ruth Wood
[1.2.6.3.1.4.3.2.4]
b. 24 Oct 1718
9
Martha Wood
[1.2.6.3.1.4.3.2.5]
b. 17 Feb 1722
9
Ephraim Wood
[1.2.6.3.1.4.3.2.6]
b. 18 Jun 1723 d. 1746
9
Dinah Wood
[1.2.6.3.1.4.3.2.7]
b. 17 Jun 1725
9
Nehemiah Wood
[1.2.6.3.1.4.3.2.8]
b. 16 Jan 1727 d. 1796
9
Jonathan Wood
[1.2.6.3.1.4.3.2.9]
b. 16 May 1730
8
Nehemiah Wood
[1.2.6.3.1.4.3.3]
b. 14 Jul 1688 d. 4 Aug 1688
8
Ephraim Wood
[1.2.6.3.1.4.3.4]
b. 13 Oct 1689 d. 26 Jun 1713
8
Samuel Wood
[1.2.6.3.1.4.3.5]
b. 31 May 1692 d. 25 Jul 1742
+
Jane Dudley
c. 1693
8
Elizabeth Wood
[1.2.6.3.1.4.3.6]
b. 8 Apr 1694 d. 23 Jul 1731
+
Philip Turner
8
Mehitable Wood
[1.2.6.3.1.4.3.7]
b. 18 Dec 1695 d. 26 Oct 1758
James Hall
b. 1693 d. 16 Jan 1742
9
Mary Hall
[1.2.6.3.1.4.3.7.1]
b. 27 Sep 1717 d. 1778
9
James Hall
[1.2.6.3.1.4.3.7.2]
b. 20 Apr 1720 d. 2 Feb 1807
9
Mehetable Hall
[1.2.6.3.1.4.3.7.3]
b. 18 Feb 1722 d. 7 Dec 1803
9
Elizabeth Hall
[1.2.6.3.1.4.3.7.4]
b. 18 Apr 1723
9
Jane Hall
[1.2.6.3.1.4.3.7.5]
b. 5 Mar 1725
9
William Hall
[1.2.6.3.1.4.3.7.6]
b. 12 Jul 1728
9
Thomas Hall
[1.2.6.3.1.4.3.7.7]
b. 14 Jun 1730
9
Ephraim Hall
[1.2.6.3.1.4.3.7.8]
b. 21 Sep 1732 d. 29 Sep 1816
9
Gershom Hall
[1.2.6.3.1.4.3.7.9]
b. 25 Feb 1735
9
Josiah Hall
[1.2.6.3.1.4.3.7.10]
b. 27 Mar 1738 d. 1810
8
Ann Wood
[1.2.6.3.1.4.3.8]
b. 11 Apr 1700 d. 30 Jul 1793
Isaac Sargent
b. Abt 24 Feb 1695 d. 12 Apr 1742
9
John Sargent
[1.2.6.3.1.4.3.8.1]
b. 6 Mar 1722 d. Dec 1827
9
Mary Sargent
[1.2.6.3.1.4.3.8.2]
b. 22 Apr 1725 d. 12 Dec 1740
9
Ana Sargent
[1.2.6.3.1.4.3.8.3]
b. 23 Feb 1727 d. 8 May 1821
9
Isaac Sargent
[1.2.6.3.1.4.3.8.4]
b. 30 Dec 1728 d. 17 Dec 1729
9
Hannah Sargent
[1.2.6.3.1.4.3.8.5]
b. 3 Dec 1730 d. 14 Aug 1751
9
Ruth Sargent
[1.2.6.3.1.4.3.8.6]
b. 14 Oct 1732 d. 29 Aug 1808
9
Elizabeth Sargent
[1.2.6.3.1.4.3.8.7]
b. 5 Feb 1734 d. 28 Dec 1776
9
Deborah Sargent
[1.2.6.3.1.4.3.8.8]
b. 2 Feb 1736 d. 1833
9
Isaac Sargent
[1.2.6.3.1.4.3.8.9]
b. 8 Dec 1737 d. Jan 1813
8
Hannah Wood
[1.2.6.3.1.4.3.9]
b. 21 May 1703 d. 18 Mar 1764
7
Ann Wood
[1.2.6.3.1.4.4]
b. 8 Aug 1660 d. 31 Jan 1715
Benjamin Plummer
b. 23 Oct 1656 d. 8 Jul 1724
8
John Plumer
[1.2.6.3.1.4.4.1]
b. 7 May 1680 d. 16 Apr 1706
8
Benjamin Plummer, Jr
[1.2.6.3.1.4.4.2]
b. 2 Mar 1681 d. 22 Jun 1734
8
Thomas Plummer
[1.2.6.3.1.4.4.3]
b. 15 Apr 1684 d. 15 Nov 1762
Ruth Pearson
b. 2 Aug 1687 d. 16 Nov 1736
9
Samuel Plumer
[1.2.6.3.1.4.4.3.1]
b. Abt 1726 d. 18 Jul 1807
9
Thomas Plumer
[1.2.6.3.1.4.4.3.2]
b. 1714 d. 12 Mar 1770
9
Ruth Plumer
[1.2.6.3.1.4.4.3.3]
b. 5 Feb 1721 d. 24 Jun 1736
9
Mehitabel Plumer
[1.2.6.3.1.4.4.3.4]
b. Bef 1712 d. Bef 27 Feb 1714
9
Stephen Plummer
[1.2.6.3.1.4.4.3.5]
b. 20 Feb 1716 d. Bef 1737
8
Sarah Plumer
[1.2.6.3.1.4.4.4]
b. 6 Aug 1686 d. Aft 1708
8
Stephen Palmer
[1.2.6.3.1.4.4.5]
b. 1 Sep 1688
8
Ann Plumer
[1.2.6.3.1.4.4.6]
b. 18 Jan 1690 d. 28 Jun 1748
8
Mary Plummer
[1.2.6.3.1.4.4.7]
b. 28 Jul 1694 d. 28 Jun 1748
8
Martha Plummer
[1.2.6.3.1.4.4.8]
b. 2 Mar 1696 d. 6 Aug 1733
8
Nathan Plummer
[1.2.6.3.1.4.4.9]
b. 26 Feb 1701 d. 1775
7
Ruth Wood
[1.2.6.3.1.4.5]
b. 21 May 1662 d. 29 Oct 1734
Joseph Jewett
b. 1 Apr 1656 d. 30 Oct 1694
8
Ruth Jewett
[1.2.6.3.1.4.5.1]
b. 1681 d. 28 Nov 1728
8
Joshua Jewett
[1.2.6.3.1.4.5.2]
b. 26 Aug 1683 d. 15 Oct 1694
8
Hannah Jewett
[1.2.6.3.1.4.5.3]
b. 3 Apr 1685 d. 23 Nov 1685
8
Elizabeth Jewett
[1.2.6.3.1.4.5.4]
b. 3 Apr 1685
8
Joseph Jewett
[1.2.6.3.1.4.5.5]
b. 10 Apr 1687 d. 10 Aug 1747
8
Sarah Jewett
[1.2.6.3.1.4.5.6]
b. 3 Feb 1689 d. 20 Nov 1722
8
Priscilla Jewett
[1.2.6.3.1.4.5.7]
b. 1 Feb 1690 d. 27 Dec 1722
Hilkiah Boynton
b. 19 Nov 1687 d. 16 Nov 1745
9
Joanna Boynton
[1.2.6.3.1.4.5.7.1]
b. 17 Aug 1712 d. Aft 7 Aug 1753
John Grout
b. 14 Oct 1704 d. Jun 1771
10
Johanna Grout
[1.2.6.3.1.4.5.7.1.1]
b. 8 Jan 1728/1729
10
Hilkiah Grout
[1.2.6.3.1.4.5.7.1.2]
b. 23 Jul 1728 d. 12 Dec 1795
10
John Grout, Jr
[1.2.6.3.1.4.5.7.1.3]
b. 13 Jun 1731 d. Aft 1779
Phebe Spofford
b. 1 Jul 1733
11
Phebe Grout
[1.2.6.3.1.4.5.7.1.3.1]
b. 21 Mar 1751 d. 1819
Jacob Winn
b. 20 Oct 1744
12
Augustus Winn
[1.2.6.3.1.4.5.7.1.3.1.1]
b. 18 Dec 1769 d. 24 Jun 1785
12
Lucend Winn
[1.2.6.3.1.4.5.7.1.3.1.2]
b. 12 Mar 1771
12
Phebe Winn
[1.2.6.3.1.4.5.7.1.3.1.3]
b. 7 Feb 1773 d. 23 May 1809
12
Endymia Winn
[1.2.6.3.1.4.5.7.1.3.1.4]
b. 1775 d. 1794 [
=>
]
11
Elijah Grout
[1.2.6.3.1.4.5.7.1.3.2]
b. 26 Jan 1753
11
Susannah Grout
[1.2.6.3.1.4.5.7.1.3.3]
b. 12 Dec 1754
11
Endymia Grout
[1.2.6.3.1.4.5.7.1.3.4]
b. 23 Dec 1756 d. 24 Apr 1759
11
Theodore Grout
[1.2.6.3.1.4.5.7.1.3.5]
b. 23 Aug 1759
11
Endymia Grout
[1.2.6.3.1.4.5.7.1.3.6]
b. 5 Aug 1761
11
John Butler Grout
[1.2.6.3.1.4.5.7.1.3.7]
b. 28 Apr 1763
11
Ferdinand Grout
[1.2.6.3.1.4.5.7.1.3.8]
b. 5 May 1765
11
Theodore Grout
[1.2.6.3.1.4.5.7.1.3.9]
b. 1 Feb 1767 d. 1831
11
Frederica Grout
[1.2.6.3.1.4.5.7.1.3.10]
b. 1 Dec 1768
11
Margaret Bradstreet Grout
[1.2.6.3.1.4.5.7.1.3.11]
b. 10 Apr 1771
10
Elijah Grout
[1.2.6.3.1.4.5.7.1.4]
b. 29 Oct 1732 d. Mar 1807
10
Joel Grout
[1.2.6.3.1.4.5.7.1.5]
b. 6 Mar 1734 d. 8 Sep 1797
10
Jonathan Grout
[1.2.6.3.1.4.5.7.1.6]
b. 23 Jul 1737 d. 8 Sep 1807
10
Sarah Grout
[1.2.6.3.1.4.5.7.1.7]
b. 28 Nov 1738 d. 21 Oct 1817
10
Patience Grout
[1.2.6.3.1.4.5.7.1.8]
b. 23 Aug 1740 d. 7 May 1810
10
Peter Grout
[1.2.6.3.1.4.5.7.1.9]
b. 9 Oct 1743
10
Abigail Grout
[1.2.6.3.1.4.5.7.1.10]
b. 23 Mar 1745 d. 14 Sep 1838
10
Josiah Grout
[1.2.6.3.1.4.5.7.1.11]
b. 28 Nov 1748 d. Bef 8 Jan 1777
10
Solomon Grout
[1.2.6.3.1.4.5.7.1.12]
b. 27 Jun 1751 d. 1787
10
Jehosaphat Grout
[1.2.6.3.1.4.5.7.1.13]
b. 7 Aug 1753 d. 6 Sep 1806
9
Priscilla Boynton
[1.2.6.3.1.4.5.7.2]
b. 11 Apr 1714 d. 1 Jan 1781
9
Hilikia Boynton
[1.2.6.3.1.4.5.7.3]
b. 11 Apr 1714 d. 28 Apr 1714
9
Joseph Boynton
[1.2.6.3.1.4.5.7.4]
b. 4 Dec 1717 d. 8 Feb 1718
9
Sarah Boynton
[1.2.6.3.1.4.5.7.5]
b. Abt 1718
9
Ruth Boynton
[1.2.6.3.1.4.5.7.6]
b. 1721 d. Jul 1721
9
Jane Boynton
[1.2.6.3.1.4.5.7.7]
b. 4 Mar 1722 d. 1743
8
Johanna Jewett
[1.2.6.3.1.4.5.8]
b. 12 Apr 1693 d. 26 Jul 1748
8
Joshua Jewett
[1.2.6.3.1.4.5.9]
b. 16 Feb 1695 d. 31 Oct 1760
7
Elizabeth Wood
[1.2.6.3.1.4.6]
b. 5 Sep 1664 d. Aft 1680
+
Captain Joseph Boynton
b. 13 May 1644 d. 16 Dec 1730
7
Josiah Wood
[1.2.6.3.1.4.7]
b. 5 Sep 1664 d. 10 Dec 1728
Mary Felt
b. Abt 1661 d. 4 Aug 1753
8
Samuel Wood
[1.2.6.3.1.4.7.1]
b. 4 Nov 1691
8
Sarah Wood
[1.2.6.3.1.4.7.2]
b. 15 Feb 1693 d. 10 Nov 1782
8
James Wood
[1.2.6.3.1.4.7.3]
b. 9 Apr 1695
8
Mary Wood
[1.2.6.3.1.4.7.4]
b. 28 Jan 1698 d. 3 Mar 1776
8
Josiah Wood
[1.2.6.3.1.4.7.5]
b. 14 Mar 1701 d. 7 Nov 1763
8
Ruth Wood
[1.2.6.3.1.4.7.6]
b. 4 Jun 1704
8
Elizabeth Wood
[1.2.6.3.1.4.7.7]
b. 26 May 1706 d. 1775
8
George Wood
[1.2.6.3.1.4.7.8]
b. 13 Aug 1708 d. Abt 1773
8
Anne Wood
[1.2.6.3.1.4.7.9]
b. 21 Dec 1710 d. 12 Nov 1783
8
Daniel David Wood
[1.2.6.3.1.4.7.10]
b. 13 Mar 1714 d. 16 May 1783
7
Samuel Wood
[1.2.6.3.1.4.8]
b. 26 Dec 1666 d. 25 Nov 1690
Margaret Elithorpe
b. 24 Jul 1672 d. 25 Jan 1754
8
Thomas Wood
[1.2.6.3.1.4.8.1]
b. 4 Mar 1689
7
Ebenezer Wood
[1.2.6.3.1.4.9]
b. 7 May 1669 d. 16 Feb 1737
+
Johanna Gage
b. Abt 1668 d. Aft 1737
7
Solomon Wood
[1.2.6.3.1.4.10]
b. 17 May 1669 d. 13 Jan 1752
7
James Wood
[1.2.6.3.1.4.11]
b. 22 Jun 1674 d. 18 Oct 1694
6
William Hunt
[1.2.6.3.1.5]
b. Abt 1635 d. 6 Sep 1694
6
Hannah Ann Hunt
[1.2.6.3.1.6]
b. 14 Feb 1640 d. 25 May 1721
Daniel White
b. Abt 1649 d. 6 May 1724
7
Joseph White
[1.2.6.3.1.6.1]
b. 17 Dec 1662 d. 28 Oct 1757
Susanna Sherman
b. Abt 1678 d. 22 Dec 1766
8
Hannah White
[1.2.6.3.1.6.1.1]
b. 28 Mar 1702 d. 29 Jul 1775
8
Abijah White
[1.2.6.3.1.6.1.2]
b. 8 Oct 1706 d. 20 Oct 1775
Anna Little
b. 30 Jan 1715 d. 11 Mar 1791
9
Anna White
[1.2.6.3.1.6.1.2.1]
b. 1739 d. Bef 1829
9
Persilla White
[1.2.6.3.1.6.1.2.2]
b. 1740 d. Bef 1830
9
Sylvanus White
[1.2.6.3.1.6.1.2.3]
b. 1742
9
Abijah White
[1.2.6.3.1.6.1.2.4]
b. 1745 d. 8 Feb 1746
9
Deborah White
[1.2.6.3.1.6.1.2.5]
b. 20 Aug 1746 d. 19 Oct 1746
9
Abijah White
[1.2.6.3.1.6.1.2.6]
b. 1747 d. 1777
9
Sarah White
[1.2.6.3.1.6.1.2.7]
b. 29 Mar 1749 d. Bef 1839
9
William White
[1.2.6.3.1.6.1.2.8]
b. Abt 1752 d. 19 Dec 1817
9
John White
[1.2.6.3.1.6.1.2.9]
b. 9 Sep 1753 d. 1 Feb 1774
9
Susanna White
[1.2.6.3.1.6.1.2.10]
b. 1756 d. 10 Apr 1793
9
Anna White
[1.2.6.3.1.6.1.2.11]
b. 27 Oct 1759
9
Persilla White
[1.2.6.3.1.6.1.2.12]
b. 17 Oct 1760
8
Cornelius White
[1.2.6.3.1.6.1.3]
b. 29 Jan 1711 d. 8 Nov 1800
Hannah Riggs
b. Abt 1670 d. Aft 1752
9
Prudence White
[1.2.6.3.1.6.1.3.1]
b. Abt 1741
9
Mose White
[1.2.6.3.1.6.1.3.2]
b. 2 Aug 1743 d. 6 Mar 1829
9
Sarah White
[1.2.6.3.1.6.1.3.3]
b. Abt 1748 d. Bef 1848
9
Mary White
[1.2.6.3.1.6.1.3.4]
b. Abt 1749 d. 10 Mar 1838
9
Hannah White
[1.2.6.3.1.6.1.3.5]
b. 1 Jan 1750
9
Asa White
[1.2.6.3.1.6.1.3.6]
b. 4 Aug 1752 d. 17 Jan 1822
8
Sarah White
[1.2.6.3.1.6.1.4]
b. 31 May 1710 d. 15 Feb 1788
Isaac Phillips
b. 5 Mar 1701 d. 18 Sep 1787
9
Isaac Phillips, Jr
[1.2.6.3.1.6.1.4.1]
b. 16 Dec 1728 d. 11 Jun 1831
9
David Phillips
[1.2.6.3.1.6.1.4.2]
b. 17 Aug 1731
9
Sarah Phillips
[1.2.6.3.1.6.1.4.3]
b. 4 Apr 1735 d. 26 Jul 1760
9
Anna Phillips
[1.2.6.3.1.6.1.4.4]
b. 15 Mar 1736 d. 19 Jan 1819
9
James Phillips
[1.2.6.3.1.6.1.4.5]
b. 30 Mar 1739
9
Rebekah Phillips
[1.2.6.3.1.6.1.4.6]
b. 21 Mar 1742
9
Joseph Phillips
[1.2.6.3.1.6.1.4.7]
b. 1 Dec 1749 d. 1751
9
Solomon Phillips
[1.2.6.3.1.6.1.4.8]
b. Dec 1750
8
Rebekah White
[1.2.6.3.1.6.1.5]
b. 17 Dec 1713 d. 1716
8
Sylvanus White
[1.2.6.3.1.6.1.6]
b. 24 Jul 1718 d. 19 Dec 1742
8
Jesse White
[1.2.6.3.1.6.1.7]
b. 7 Dec 1720 d. 1765
Catherina Charlotte Wilhelmina Subellina Warner
b. Abt 1720 d. Abt 1771
9
Sybelene White
[1.2.6.3.1.6.1.7.1]
b. 1744 d. May 1747
9
Sybelene White
[1.2.6.3.1.6.1.7.2]
b. 1748
9
Christiana White
[1.2.6.3.1.6.1.7.3]
b. 1750 d. 5 Aug 1818
Lydia Copeland
b. 27 Mar 1642 d. 8 May 1727
8
Mary White
[1.2.6.3.1.6.1.8]
b. 27 Feb 1682 d. 1701
8
Captain Joseph White
[1.2.6.3.1.6.1.9]
b. 19 Oct 1683 d. 15 Jun 1737
Prudence Smith
b. 19 Jul 1691 d. 5 Apr 1785
9
Joseph White
[1.2.6.3.1.6.1.9.1]
b. 22 Sep 1712 d. 12 Mar 1788
Judeth Clarke
b. 1711 d. 3 Feb 1794
10
Sarah White
[1.2.6.3.1.6.1.9.1.1]
b. 1735 d. 1747
10
Tryal White
[1.2.6.3.1.6.1.9.1.2]
b. 8 May 1737 d. 14 Jun 1814
Lieutenant Abner Taft
b. 28 Dec 1736 d. 30 May 1809
11
Oliver Taft
[1.2.6.3.1.6.1.9.1.2.1]
b. 1 May 1758 d. 16 Jul 1775
11
Moses Taft
[1.2.6.3.1.6.1.9.1.2.2]
b. 29 Sep 1760 d. 4 Dec 1848
Judith Cummings
b. 26 Nov 1766 d. 26 Nov 1816
12
Nancy Taft
[1.2.6.3.1.6.1.9.1.2.2.1]
b. 10 Mar 1787
12
Samuel Taft
[1.2.6.3.1.6.1.9.1.2.2.2]
b. 24 Sep 1790 d. 11 Oct 1863
12
Lucy Taft
[1.2.6.3.1.6.1.9.1.2.2.3]
b. 24 Apr 1795 d. 21 Jun 1847
12
Newell Taft
[1.2.6.3.1.6.1.9.1.2.2.4]
b. 28 Jul 1804 d. 4 Nov 1873 [
=>
]
12
Sylvia Taft
[1.2.6.3.1.6.1.9.1.2.2.5]
b. 23 Aug 1810 d. 3 Aug 1816
11
Mary Taft
[1.2.6.3.1.6.1.9.1.2.3]
b. 12 Oct 1767 d. 18 Aug 1775
11
Webb Taft
[1.2.6.3.1.6.1.9.1.2.4]
b. 26 Mar 1772 d. 21 Apr 1842
Lucy Taft
b. 9 Jun 1774 d. 14 Mar 1846
12
Lucinda Taft
[1.2.6.3.1.6.1.9.1.2.4.1]
b. 22 Nov 1793
12
Jason Taft
[1.2.6.3.1.6.1.9.1.2.4.2]
b. 5 Jun 1796 d. 25 Oct 1861
11
Trial T Taft
[1.2.6.3.1.6.1.9.1.2.5]
b. 13 Apr 1777 d. 18 Aug 1815
10
Lois White
[1.2.6.3.1.6.1.9.1.3]
b. 25 Aug 1739 d. 7 Jan 1806
Edward Seagrave
b. Abt 1722 d. 20 May 1793
11
John Seagrave
[1.2.6.3.1.6.1.9.1.3.1]
b. 6 Nov 1757 d. 3 Feb 1842
11
Lois Seagrave
[1.2.6.3.1.6.1.9.1.3.2]
b. 5 Nov 1759 d. 8 Mar 1819
11
Sarah Sally Seagrave
[1.2.6.3.1.6.1.9.1.3.3]
b. 31 Dec 1760 d. 12 May 1851
11
Joseph Seagrave
[1.2.6.3.1.6.1.9.1.3.4]
b. 21 Dec 1761 d. 30 Aug 1830
11
Mary Seagrave
[1.2.6.3.1.6.1.9.1.3.5]
b. 1 Apr 1764 d. 1777
11
Bezaleel Seagrave
[1.2.6.3.1.6.1.9.1.3.6]
b. 14 Dec 1766 d. 1 Aug 1830
11
Caleb Seagrave
[1.2.6.3.1.6.1.9.1.3.7]
b. 14 Mar 1771 d. 22 Sep 1836
11
Josiah Seagrave
[1.2.6.3.1.6.1.9.1.3.8]
b. 14 Oct 1773 d. 20 Mar 1855
Lois Taft
b. 27 Aug 1780 d. 27 Apr 1854
12
Mary Ann Seagrave
[1.2.6.3.1.6.1.9.1.3.8.1]
b. 17 Nov 1799 d. 10 Feb 1825
12
Jacob Taft Seagraves
[1.2.6.3.1.6.1.9.1.3.8.2]
b. 8 Apr 1802 d. 24 Sep 1870
12
Henrietta Frost Seagrave
[1.2.6.3.1.6.1.9.1.3.8.3]
b. 1 Dec 1803 d. 1 Jun 1823
12
Waity Grant Seagrave
[1.2.6.3.1.6.1.9.1.3.8.4]
b. 23 Sep 1805 d. 27 Jan 1859
12
Edward Seagrave
[1.2.6.3.1.6.1.9.1.3.8.5]
b. 3 Sep 1807 d. 15 Feb 1873
12
Lois Taft Seagrave
[1.2.6.3.1.6.1.9.1.3.8.6]
b. 13 Apr 1809 d. 19 Mar 1853
12
Josiah Seagrave, Jr
[1.2.6.3.1.6.1.9.1.3.8.7]
b. 24 May 1811 d. 21 Jul 1861
12
Malvina Seagrave
[1.2.6.3.1.6.1.9.1.3.8.8]
b. 2 Apr 1813 d. 16 Dec 1823
12
Caleb Seagrave
[1.2.6.3.1.6.1.9.1.3.8.9]
b. 8 Feb 1815 d. 14 Nov 1823
12
Son Seagrave
[1.2.6.3.1.6.1.9.1.3.8.10]
b. 3 May 1817 d. 3 May 1817
12
Daughter Seagrave
[1.2.6.3.1.6.1.9.1.3.8.11]
b. 3 May 1817 d. 3 May 1817
12
Esborn Seagrave
[1.2.6.3.1.6.1.9.1.3.8.12]
b. 28 Dec 1818 d. 27 Oct 1856
12
George Augustus Seagrave
[1.2.6.3.1.6.1.9.1.3.8.13]
b. 6 Jan 1823 d. 15 Nov 1884
11
Edward Seagrave
[1.2.6.3.1.6.1.9.1.3.9]
b. 14 Oct 1773 d. 31 Jul 1797
11
Olive Seagrave
[1.2.6.3.1.6.1.9.1.3.10]
b. 17 Apr 1779 d. 1868
11
Samuel Seagraves
[1.2.6.3.1.6.1.9.1.3.11]
b. 3 Feb 1782 d. 4 Feb 1855
10
Joseph White
[1.2.6.3.1.6.1.9.1.4]
b. 1744 d. 1747
10
Judith White
[1.2.6.3.1.6.1.9.1.5]
b. 1746 d. 1747
10
Amos White
[1.2.6.3.1.6.1.9.1.6]
b. 1748 d. 1782
10
Joel White
[1.2.6.3.1.6.1.9.1.7]
b. 1751 d. 1835
10
Jesse White
[1.2.6.3.1.6.1.9.1.8]
b. 1754 d. 1830
10
Edward White
[1.2.6.3.1.6.1.9.1.9]
b. 1756 d. 1756
10
Abner White
[1.2.6.3.1.6.1.9.1.10]
b. 1758 d. 1758
10
Moses White
[1.2.6.3.1.6.1.9.1.11]
b. 1759 d. 1759
10
Eunice White
[1.2.6.3.1.6.1.9.1.12]
b. 1 Nov 1741 d. 3 Apr 1825
9
Peter White
[1.2.6.3.1.6.1.9.2]
b. 6 Dec 1714 d. 8 May 1782
Jemima Taft
b. 1 Apr 1713 d. 14 Oct 1787
10
Joseph White
[1.2.6.3.1.6.1.9.2.1]
b. 25 Jun 1738 d. 1805
10
Bethaih White
[1.2.6.3.1.6.1.9.2.2]
b. 1 Mar 1740 d. 1809
10
Elisabeth White
[1.2.6.3.1.6.1.9.2.3]
b. 13 Dec 1743
10
Peter White
[1.2.6.3.1.6.1.9.2.4]
b. 1746 d. 2 Dec 1821
10
Jemima White
[1.2.6.3.1.6.1.9.2.5]
b. Abt 1754 d. Abt 1782
10
Nathan White
[1.2.6.3.1.6.1.9.2.6]
b. 10 Jan 1755 d. 21 Jan 1828
9
Aaron White
[1.2.6.3.1.6.1.9.3]
b. 22 May 1717 d. Abt 1760
+
Susanah Benson
b. 2 Aug 1721 d. Aft 1750
9
Moses White
[1.2.6.3.1.6.1.9.4]
b. 31 Aug 1721
Abigail Holbrook
b. Abt 1721 d. 1787
10
Stephen White
[1.2.6.3.1.6.1.9.4.1]
b. 22 Sep 1754
10
Moses White
[1.2.6.3.1.6.1.9.4.2]
b. 24 Jul 1751
10
Abner White
[1.2.6.3.1.6.1.9.4.3]
b. 27 May 1753
9
Abigail White
[1.2.6.3.1.6.1.9.5]
b. 27 Jan 1723 d. 4 May 1751
Benoni Benson
b. 18 Jul 1724 d. 10 Jan 1806
10
Stephen Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.1]
b. 15 Jul 1742 d. 30 Jul 1823
Mary Holbrook
b. 15 Jul 1745 d. 1849
11
Ichabod Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.1.1]
b. 30 Dec 1764 d. Aug 1794
Polly Herrick
b. 16 Aug 1763 d. 4 Oct 1847
12
Alonzo Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.1.1.1]
b. 6 Jan 1794 d. 4 Jun 1881 [
=>
]
11
Elkanah Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.1.2]
b. 21 Feb 1766 d. 8 Mar 1844
Deobrah Wheelock
b. 17 Dec 1765 d. 3 Aug 1846
12
Samuel Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.1.2.1]
b. 21 May 1791 [
=>
]
12
Chloe Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.1.2.2]
b. 6 Jan 1793 d. 1882 [
=>
]
12
Adolphus Willard Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.1.2.3]
b. 17 Dec 1795 d. 18 May 1878 [
=>
]
12
Eliza Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.1.2.4]
b. 9 Mar 1798 d. 13 Nov 1817
12
Leonard Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.1.2.5]
b. 7 Apr 1800 d. 7 Sep 1877 [
=>
]
12
Phila Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.1.2.6]
b. 27 Jul 1802 [
=>
]
12
Calista Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.1.2.7]
b. 2 Jun 1804 d. 15 Sep 1882 [
=>
]
12
Ruth Wheelock Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.1.2.8]
b. 21 Sep 1807 [
=>
]
12
Sarah Elizabeth Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.1.2.9]
b. 1 Jul 1809 d. 20 Jul 1888 [
=>
]
11
Esther Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.1.3]
b. 8 Dec 1768 d. 31 Mar 1855
Isaac Staples
b. 9 Mar 1742 d. 29 May 1848
12
Esther Staples
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.1.3.1]
b. Abt 1790 d. 17 May 1878
12
Abraham Staples
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.1.3.2]
b. 12 Mar 1792 d. 5 Sep 1881
12
Scammel Staples
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.1.3.3]
b. 29 Dec 1798 d. 5 Apr 1883
12
Warren Staples
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.1.3.4]
b. 17 Jan 1802
12
Evaline Staples
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.1.3.5]
b. 11 Aug 1807 d. 2 Oct 1858
11
Ezekial Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.1.4]
b. 13 Mar 1770
11
Phila Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.1.5]
b. 23 Feb 1772
Phineas Tyler
b. 14 Feb 1765 d. 21 Jan 1847
12
Daniel Tyler
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.1.5.1]
b. 2 Aug 1791
12
Phila Tyler
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.1.5.2]
b. Abt 1793
12
Mary Tyler
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.1.5.3]
b. 30 Mar 1794 d. 5 Aug 1885 [
=>
]
11
Polly Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.1.6]
b. 7 Nov 1773
John Robinson
b. Abt 1769
12
Tryphenia Robinson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.1.6.1]
b. Abt 1795
12
Lydia Robinson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.1.6.2]
b. Abt 1797
12
Ezekial Robinson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.1.6.3]
b. Abt 1799
12
Hiram Robinson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.1.6.4]
b. Abt 1801
12
Andrew Robinson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.1.6.5]
b. Abt 1803
12
John Robinson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.1.6.6]
b. Abt 1805
12
Norman Robinson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.1.6.7]
b. Abt 1807
11
Sally Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.1.7]
b. 13 Feb 1776 d. 24 Nov 1837
Amos Boyden
b. 1766 d. 30 Apr 1836
12
Abigail Boyden
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.1.7.1]
b. 6 Aug 1791 [
=>
]
12
Aseneth Boyden
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.1.7.2]
b. 10 Sep 1794 d. Apr 1886
12
David Boyden
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.1.7.3]
b. 11 Mar 1797
12
Nancy Boyden
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.1.7.4]
b. 23 Mar 1799
12
Sally Boyden
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.1.7.5]
b. 3 Apr 1806 d. 13 Sep 1808
12
William Collins Boyden
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.1.7.6]
b. 14 May 1801 d. 30 Nov 1803
12
Joel Boyden
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.1.7.7]
b. 7 Jul 1803 d. 2 Aug 1835 [
=>
]
12
Amy Smith Boyden
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.1.7.8]
b. 10 Jul 1808 d. 31 Jul 1838
12
William Collins Boyden
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.1.7.9]
b. 8 May 1811 [
=>
]
10
Henry Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.2]
b. 5 Dec 1743 d. 7 Dec 1777
Susanna Thayer
b. 23 Apr 1746 d. 4 Jan 1808
11
Hannah Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.2.1]
b. 7 May 1764
+
Aaron Legg
11
Joanna Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.2.2]
b. 6 Jul 1766 d. 29 Dec 1820
Daniel Holbrook
b. 7 Feb 1765 d. 10 Jun 1831
12
Henry Benson Holbrook
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.2.2.1]
b. 21 Aug 1788 d. 1870 [
=>
]
12
Marcus Holbrook
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.2.2.2]
b. Abt 1791 d. Aft 1840
12
Lydia Holbrook
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.2.2.3]
b. Abt 1793 d. 19 Feb 1820
12
Daniel Holbrook
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.2.2.4]
b. 28 Feb 1796 d. 18 Oct 1864
12
Rufus Holbrook
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.2.2.5]
b. Abt 1801 [
=>
]
12
Abraham Staples Holbrook
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.2.2.6]
b. Abt 1806 d. 1 May 1862
12
Millins Holbrook
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.2.2.7]
b. Abt 1808 [
=>
]
11
Abigail Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.2.3]
b. 2 Jul 1768
+
Henry Staples
11
Henry Staples Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.2.4]
b. 8 Aug 1770 d. 29 Jul 1821
Lydia Sibley
b. 2 Apr 1769 d. 27 Nov 1822
12
Abigail Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.2.4.1]
b. 31 Mar 1795 d. 10 Nov 1821 [
=>
]
12
Harriet Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.2.4.2]
b. 14 Sep 1796 d. 22 Aug 1852
12
Mellen Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.2.4.3]
b. 14 Jan 1798 [
=>
]
12
Hannah Adaline Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.2.4.4]
b. 12 Aug 1802 d. 19 Jun 1822
12
Rufus Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.2.4.5]
b. 24 Jan 1804 d. 23 Aug 1805
12
Chloe Ann Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.2.4.6]
b. 23 Aug 1806
12
Susan Augusta Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.2.4.7]
b. 9 Oct 1809 d. 25 Jul 1831 [
=>
]
12
Rufus Aldrich Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.2.4.8]
b. 9 Oct 1809
12
Stephen Sibley Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.2.4.9]
b. 9 Jan 1810 d. 20 Nov 1869 [
=>
]
11
Tirza Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.2.5]
b. 29 Apr 1772
Wilder Johnson
b. 1768
12
Elmira Johnson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.2.5.1]
b. 1810 d. 27 May 1816
11
Susanna Thayer Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.2.6]
b. 19 Feb 1775
+
Gideon Angel
b. Abt 1770
11
Rachel Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.2.7]
b. 5 May 1777 d. 21 Nov 1842
General Charles Jenckes
b. 7 Aug 1767 d. 4 Jul 1838
12
Charles Benson Jenckes
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.2.7.1]
b. 10 Apr 1796 d. Aft 1831 [
=>
]
10
Joanna Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.3]
b. 14 Nov 1745 d. Bef 1806
10
Benoni Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.4]
b. 11 Jul 1747 d. 1803
Ruth Holbrook
b. 10 Aug 1751 d. 16 May 1781
11
Amasa Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.4.1]
b. 25 Jan 1771 d. 7 Mar 1837
Levina Turtilot
b. 20 Feb 1777 d. 1 May 1865
12
Henry Holbrook Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.4.1.1]
b. 22 Mar 1801 [
=>
]
12
James Davis Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.4.1.2]
b. 15 Nov 1802 d. 5 Sep 1805
12
Chloe Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.4.1.3]
b. 2 Oct 1804 d. 28 Mar 1844 [
=>
]
12
Maria R Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.4.1.4]
b. 17 Dec 1806 [
=>
]
12
Charles Holbrook Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.4.1.5]
b. 14 Sep 1809
12
Angeline Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.4.1.6]
b. 20 Jul 1811
12
Ann Eliza Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.4.1.7]
b. 20 Feb 1813
12
Elsa T Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.4.1.8]
b. 17 Jul 1815
12
Nathan Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.4.1.9]
b. 30 Nov 1817
12
William Hall Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.4.1.10]
b. 24 Oct 1819
11
Chloe Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.4.2]
b. 28 Jan 1774
11
Benoni Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.4.3]
b. 1780 d. 1819
Ruth Sibley
b. 9 Apr 1745 d. 30 Nov 1814
11
John Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.4.4]
b. 1789
10
John Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.5]
b. 1 Aug 1749 d. 18 May 1818
Mary Holbrook
b. 1 Feb 1762 d. 27 Dec 1814
11
John Perry Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.1]
b. 22 Jul 1781 d. 21 Jan 1842
Chloe Taft
b. 7 Jul 1785 d. 25 Apr 1826
12
Charlotte Taft Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.1.1]
b. 30 Sep 1807 d. 16 Jul 1878 [
=>
]
12
Ezra Taft Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.1.2]
b. 22 Feb 1811 d. 3 Sep 1869 [
=>
]
12
George Taft Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.1.3]
b. Abt 1813 [
=>
]
12
Hannah Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.1.4]
b. 18 Sep 1816 [
=>
]
12
Abbie Ann Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.1.5]
b. Abt 1809 d. 21 Sep 1883 [
=>
]
12
John M Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.1.6]
b. 1819 d. 12 Aug 1829
11
George Washington Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.2]
b. 25 May 1783 d. 10 Nov 1855
Alinda Warfield
b. 24 Aug 1785 d. 25 Apr 1841
12
Otis Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.2.1]
b. 28 Feb 1806 d. 16 Feb 1811
12
Harrison Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.2.2]
b. 10 Oct 1820 d. 25 Oct 1859 [
=>
]
11
Jared Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.3]
b. 3 Feb 1785 d. 31 Jul 1854
Salley Taft
b. 21 Oct 1787 d. 7 Aug 1855
12
James Sulliven Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.3.1]
b. 19 Sep 1808 d. 3 Jan 1833
12
Putman Taft Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.3.2]
b. 28 Oct 1814 d. 24 Apr 1834
12
Jared Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.3.3]
b. 8 Nov 1821 d. 18 May 1894 [
=>
]
12
Sylvanus Holbrook Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.3.4]
b. 23 Jun 1828 d. 1878 [
=>
]
11
Abigail Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.4]
b. 13 Feb 1787
Putman Taft
b. 5 Aug 1783 d. 20 Feb 1810
12
Mary Ann Taft
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.4.1]
b. 23 Oct 1807
11
Mary "Polly" Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.5]
b. 9 Jun 1788 d. 12 Jan 1864
Bailey Legg
b. 9 May 1783 d. 11 Oct 1862
12
Sylvanus B Legg
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.5.1]
b. 20 Jun 1813 d. Bef 8 Jun 1885
12
Mary H Legg
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.5.2]
b. 7 Jul 1815
12
Harriet H Legg
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.5.3]
b. 14 Jun 1817
11
Phyba Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.6]
b. Abt 1790
11
Prudence Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.7]
b. 7 Jul 1795
11
Thankful Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.8]
b. 26 Nov 1799 d. 1 May 1852
Joseph Bartlett Cook
b. 3 Dec 1796 d. 6 Oct 1856
12
William Walker Cook
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.8.1]
b. 21 Mar 1820 [
=>
]
12
Amanda Melvina Cook
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.8.2]
b. 12 Oct 1821
12
Mary Adeliza Cook
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.8.3]
b. 18 Apr 1824
12
Emily Caroline Cook
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.8.4]
b. 8 Feb 1826 d. 7 Mar 1826
12
Elma Ann Cook
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.8.5]
b. 29 Jan 1827 d. 13 Jan 1870 [
=>
]
11
Sulvanus Holbrook Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.9]
b. 12 Jan 1797 d. 24 Aug 1812
11
Judson Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.10]
b. Abt 1801 d. 15 Oct 1813
Joanna Taft
b. 14 Nov 1751 d. 3 Oct 1777
11
Lovett Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.11]
b. 6 Oct 1772 d. 4 Mar 1773
11
Lois Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.12]
b. 17 Jul 1774 d. 10 Jul 1840
Manassah Baker
b. 4 Oct 1765 d. 30 Jun 1831
12
Sarah Williams Baker
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.12.1]
b. 8 Feb 1796 [
=>
]
12
Sawyer Baker
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.12.2]
b. 5 Nov 1797 d. 14 Oct 1802
12
Mary Sawyer Baker
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.12.3]
b. 1 Apr 1800
12
Bezaleel Sawyer Baker
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.12.4]
b. 13 Sep 1802
12
William Henry Baker
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.12.5]
b. 8 Jun 1805
12
Chloe Taft Baker
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.12.6]
b. 17 Dec 1807 [
=>
]
12
John William Baker
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.12.7]
b. 29 Sep 1810
12
Hannah Dike Baker
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.12.8]
b. 8 Nov 1813 d. 3 Jul 1836
12
John Brooks Baker
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.12.9]
b. 30 Jul 1816
12
Caleb Strong Baker
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.12.10]
b. 30 Jul 1816 d. 29 Dec 1834
11
Prudence Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.13]
b. 4 May 1776 d. 16 May 1789
10
Ichabod Benson
[1.2.6.3.1.6.1.9.5.6]
b. 4 May 1751 d. Bef 1806
9
Sarah White
[1.2.6.3.1.6.1.9.6]
b. 8 Nov 1724
9
Ebenezer White
[1.2.6.3.1.6.1.9.7]
b. 20 Nov 1726 d. 10 May 1812
Elizabeth Ellis
b. 10 Dec 1729
10
Ellis White
[1.2.6.3.1.6.1.9.7.1]
b. 13 Oct 1748
10
Turner White
[1.2.6.3.1.6.1.9.7.2]
b. Abt 1750 d. 6 Aug 1836
10
Abigail White
[1.2.6.3.1.6.1.9.7.3]
b. 9 Sep 1752
10
Smith White
[1.2.6.3.1.6.1.9.7.4]
b. 9 Oct 1755 d. 18 Apr 1823
10
Philadelphia White
[1.2.6.3.1.6.1.9.7.5]
b. 6 Oct 1760
10
Melatiah White
[1.2.6.3.1.6.1.9.7.6]
b. Abt 18 May 1766
10
Stephen White
[1.2.6.3.1.6.1.9.7.7]
b. 11 May 1761 d. 20 Oct 1860
9
Prudence White
[1.2.6.3.1.6.1.9.8]
b. 24 Sep 1729 d. Feb 1787
James Albee
b. 12 Mar 1721 d. 24 Nov 1795
10
Hope Albee
[1.2.6.3.1.6.1.9.8.1]
b. Abt 1765 d. 18 Jan 1840
Stephen Holbrook
b. 19 Jun 1764 d. 16 Aug 1830
11
Rachel Holbrook
[1.2.6.3.1.6.1.9.8.1.1]
b. 22 Apr 1789
11
Sylvanus Holbrook
[1.2.6.3.1.6.1.9.8.1.2]
b. 28 Jul 1792 d. 9 Dec 1855
11
Willard Holbrook
[1.2.6.3.1.6.1.9.8.1.3]
b. 7 Apr 1795 d. 4 Mar 1862
11
Wilder Holbrook
[1.2.6.3.1.6.1.9.8.1.4]
b. 7 Apr 1795 d. 2 Jan 1855
11
Chloe Holbrook
[1.2.6.3.1.6.1.9.8.1.5]
b. 13 Aug 1801 d. 11 Aug 1855
11
Henry Holbrook
[1.2.6.3.1.6.1.9.8.1.6]
b. 19 Apr 1804 d. 10 Jul 1874
11
Ellery Holbrook
[1.2.6.3.1.6.1.9.8.1.7]
b. 26 Jun 1810 d. 10 Jul 1847
10
Rachael Albee
[1.2.6.3.1.6.1.9.8.2]
b. Abt 1748 d. 1832
10
Lois Albee
[1.2.6.3.1.6.1.9.8.3]
b. 15 Feb 1759 d. 1841
10
Eunice Albee
[1.2.6.3.1.6.1.9.8.4]
b. 20 Apr 1763 d. 1845
10
James Albee
[1.2.6.3.1.6.1.9.8.5]
b. 11 Mar 1753 d. 18 Aug 1814
10
Abigail Albee
[1.2.6.3.1.6.1.9.8.6]
b. 1747 d. 1844
10
Alpheus Albee
[1.2.6.3.1.6.1.9.8.7]
b. 15 Feb 1761 d. 1847
10
Prudance Albe
[1.2.6.3.1.6.1.9.8.8]
b. 18 Jan 1770 d. 1795
10
Abiel Albee
[1.2.6.3.1.6.1.9.8.9]
b. 1756 d. 1827
9
Rachael White
[1.2.6.3.1.6.1.9.9]
b. 14 Nov 1732 d. 19 Mar 1808
Thomas Darling
b. 7 May 1730 d. 22 Oct 1776
10
Seth Darling
[1.2.6.3.1.6.1.9.9.1]
b. 21 Mar 1764 d. 27 Mar 1825
10
Nathan Darling
[1.2.6.3.1.6.1.9.9.2]
b. 17 Dec 1770 d. 7 Sep 1855
10
Simeon Darling
[1.2.6.3.1.6.1.9.9.3]
b. 21 Mar 1760 d. 4 Jun 1812
10
John Darling
[1.2.6.3.1.6.1.9.9.4]
b. 9 Jun 1768
10
Alpheus Darling
[1.2.6.3.1.6.1.9.9.5]
b. Abt 1770
10
Rhoda Darling
[1.2.6.3.1.6.1.9.9.6]
b. 8 May 1750 d. 25 Jan 1842
10
Joanna Darling
[1.2.6.3.1.6.1.9.9.7]
b. 1 Feb 1752
10
Rachel Darling
[1.2.6.3.1.6.1.9.9.8]
b. 1 May 1755 d. Bef 1818
Reuben Holbrook
b. 18 Jul 1754 d. 1835
11
Abigail Holbrook
[1.2.6.3.1.6.1.9.9.8.1]
b. 8 Jan 1778
11
Rachael Holbrook
[1.2.6.3.1.6.1.9.9.8.2]
b. 8 Jan 1780
Foster Verry
b. 7 Oct 1789 d. 1860
12
Albert Verry
[1.2.6.3.1.6.1.9.9.8.2.1]
b. 15 Jul 1812
12
James Verry
[1.2.6.3.1.6.1.9.9.8.2.2]
b. 27 Feb 1814 [
=>
]
12
Chloe Holbrook Verry
[1.2.6.3.1.6.1.9.9.8.2.3]
b. 20 Mar 1816 [
=>
]
12
Sally Verry
[1.2.6.3.1.6.1.9.9.8.2.4]
b. 30 Apr 1818
12
Foster Verry
[1.2.6.3.1.6.1.9.9.8.2.5]
b. 3 Oct 1821 d. 29 Jun 1837
11
Prudence Holbrook
[1.2.6.3.1.6.1.9.9.8.3]
b. 25 Feb 1782
11
Anna Holbrook
[1.2.6.3.1.6.1.9.9.8.4]
b. 30 Mar 1784 d. 16 Mar 1851
Samuel Fairbanks
b. 8 Apr 1784 d. 22 Jul 1845
12
Samuel Fairbanks
[1.2.6.3.1.6.1.9.9.8.4.1]
b. Feb 1803 d. Aft 1852
12
Hester Fairbanks
[1.2.6.3.1.6.1.9.9.8.4.2]
b. 11 Apr 1804 d. Bef 1825
12
Mary Ann Fairbanks
[1.2.6.3.1.6.1.9.9.8.4.3]
b. 27 Apr 1806 d. 1858 [
=>
]
12
Elizabeth Fairbanks
[1.2.6.3.1.6.1.9.9.8.4.4]
b. 14 Nov 1814 d. 12 Oct 1872 [
=>
]
12
Benjamin Fairbanks
[1.2.6.3.1.6.1.9.9.8.4.5]
b. 17 Feb 1808 d. 7 Oct 1876 [
=>
]
12
Rachel Fairbanks
[1.2.6.3.1.6.1.9.9.8.4.6]
b. 5 Jan 1810 d. Bef 1825
12
Reuben Fairbanks
[1.2.6.3.1.6.1.9.9.8.4.7]
b. 2 Jun 1811 d. Bef 1825
12
Abbie Fairbanks
[1.2.6.3.1.6.1.9.9.8.4.8]
b. Abt 1816
12
Charles Fairbanks
[1.2.6.3.1.6.1.9.9.8.4.9]
b. 9 Mar 1817 d. 22 Oct 1869 [
=>
]
12
Abigail C Fairbanks
[1.2.6.3.1.6.1.9.9.8.4.10]
b. 11 Aug 1825 d. 30 Jun 1848 [
=>
]
11
Benjamin Holbrook
[1.2.6.3.1.6.1.9.9.8.5]
b. 31 Jan 1786
10
Prudence Darling
[1.2.6.3.1.6.1.9.9.9]
b. 28 Sep 1757 d. 1827
10
Benjamin Darling
[1.2.6.3.1.6.1.9.9.10]
b. 28 Feb 1766 d. Bef 14 Apr 1776
8
Lydia White
[1.2.6.3.1.6.1.10]
b. 10 May 1686
8
Thomas White
[1.2.6.3.1.6.1.11]
b. 26 Nov 1688 d. 10 Nov 1746
8
Hannah White
[1.2.6.3.1.6.1.12]
b. 9 Dec 1691 d. Abt 1761
8
Mary White
[1.2.6.3.1.6.1.13]
b. 1692 d. 1707
8
Abigail White
[1.2.6.3.1.6.1.14]
b. 10 Nov 1693 d. Bef 22 Mar 1720
8
Rachel White
[1.2.6.3.1.6.1.15]
b. 27 Dec 1694
7
Thomas White
[1.2.6.3.1.6.2]
b. 8 May 1680 d. 31 Mar 1762
7
Cornelius White
[1.2.6.3.1.6.3]
b. 28 Mar 1682 d. 21 Jan 1755
7
Benjamin White
[1.2.6.3.1.6.4]
b. 12 Oct 1684 d. 12 May 1724
7
Eleazar White
[1.2.6.3.1.6.5]
b. 8 Nov 1686 d. 14 Apr 1737
7
Ebenezer White
[1.2.6.3.1.6.6]
b. 3 Aug 1691 d. 18 May 1733
6
Isaac Hunt
[1.2.6.3.1.7]
b. Abt 1647 d. 12 Dec 1680
4
Mary Best
[1.2.6.4]
c. 14 Aug 1586 d. 1615
4
Elizabeth "Bridget" Best
[1.2.6.5]
b. 9 Apr 1592 d. Nov 1638
Abraham Shaw
b. 2 Jan 1590 d. 2 Nov 1638
5
Susanna Grace Shaw
[1.2.6.5.1]
b. 15 Aug 1621 d. 21 Aug 1698
Nicholas Byram
b. Abt 1610 d. 13 Apr 1688
6
Abagail Byram
[1.2.6.5.1.1]
b. 1632 d. 1712
6
Experience Byram
[1.2.6.5.1.2]
b. 1637 d. 1712
6
Deliverance Byram
[1.2.6.5.1.3]
b. 1638 d. 30 Sep 1720
John Porter
b. 1638 d. 7 Aug 1717
7
Thomas Porter
[1.2.6.5.1.3.1]
b. 1660 d. Abt 1754
7
Mary Porter
[1.2.6.5.1.3.2]
b. 22 Oct 1662 d. 24 Dec 1746
Wiliam Petty
b. 12 May 1661 d. 6 Jun 1728
8
Mary Petty
[1.2.6.5.1.3.2.1]
b. Abt 1690 d. 1756
8
Nathanial Petty
[1.2.6.5.1.3.2.2]
b. 14 Jun 1691 d. 17 Aug 1747
Mary Stowell
b. 17 Nov 1693 d. 20 Apr 1740
9
William Petty
[1.2.6.5.1.3.2.2.1]
b. 14 Sep 1715 d. 1753
Abigail Cox
b. 31 Jan 1722
10
William Petty
[1.2.6.5.1.3.2.2.1.1]
b. 23 Feb 1742
10
Joseph
[1.2.6.5.1.3.2.2.1.2]
b. Abt 1742
10
James Petty
[1.2.6.5.1.3.2.2.1.3]
b. 29 Aug 1745 d. 27 Jan 1764
10
Betty Petty
[1.2.6.5.1.3.2.2.1.4]
b. 31 Dec 1746 d. 1793
Jonathan Hadlock
b. 14 Jul 1742 d. 1801
11
Abigail Hadlock
[1.2.6.5.1.3.2.2.1.4.1]
b. 19 Mar 1769 d. 4 Apr 1769
11
Samuel Hadlock
[1.2.6.5.1.3.2.2.1.4.2]
b. 18 Jun 1770
11
Hezekiah Hadlock
[1.2.6.5.1.3.2.2.1.4.3]
b. 10 Aug 1772 d. 12 Dec 1855
11
Jonathan Hadlock
[1.2.6.5.1.3.2.2.1.4.4]
b. 28 Aug 1774
11
Joseph Hadlock
[1.2.6.5.1.3.2.2.1.4.5]
b. 4 Mar 1777 d. 4 Jun 1849
11
Elizabeth "Betsey" Hadlock
[1.2.6.5.1.3.2.2.1.4.6]
b. 24 Mar 1779 d. 1832
11
Peter Hadlock
[1.2.6.5.1.3.2.2.1.4.7]
b. 16 Sep 1781
11
Mariam Hadlock
[1.2.6.5.1.3.2.2.1.4.8]
b. 2 Mar 1784 d. 29 Jun 1851
11
Rhoda Hadlock
[1.2.6.5.1.3.2.2.1.4.9]
b. Feb 1786
11
Stephan A Hadlock
[1.2.6.5.1.3.2.2.1.4.10]
b. 12 Feb 1790 d. 9 Sep 1847
Sally Alton
b. 23 Nov 1796 d. 29 Feb 1880
12
Lucretia Hadlock
[1.2.6.5.1.3.2.2.1.4.10.1]
b. 17 Oct 1817 d. 1889
12
Persina Hadlock
[1.2.6.5.1.3.2.2.1.4.10.2]
b. 7 Dec 1819 d. Jul 1856
12
Irene Hadlock
[1.2.6.5.1.3.2.2.1.4.10.3]
b. 21 Aug 1822 d. 17 Nov 1903
12
Hathron Chauncey Hadlock
[1.2.6.5.1.3.2.2.1.4.10.4]
b. 25 May 1824 d. 3 Oct 1902
12
Oren Alton Hadlock
[1.2.6.5.1.3.2.2.1.4.10.5]
b. 11 Apr 1826 d. 1 Mar 1892
12
Chastina Hadlock
[1.2.6.5.1.3.2.2.1.4.10.6]
b. 2 Apr 1828 d. 20 Mar 1913
12
Rosina Hadlock
[1.2.6.5.1.3.2.2.1.4.10.7]
b. 15 Nov 1831 d. 3 Oct 1884
12
Sally Cecelia Hadlock
[1.2.6.5.1.3.2.2.1.4.10.8]
b. 23 Sep 1836 d. 30 Jun 1895 [
=>
]
12
Esther Adeline Hadlock
[1.2.6.5.1.3.2.2.1.4.10.9]
b. 12 Feb 1841 d. 20 Dec 1913
12
Henrietta Hadlock
[1.2.6.5.1.3.2.2.1.4.10.10]
b. 10 Jul 1843 d. 8 Aug 1928 [
=>
]
11
Amos Ward Hadlock
[1.2.6.5.1.3.2.2.1.4.11]
b. 6 Apr 1793
9
Nathanial Petty
[1.2.6.5.1.3.2.2.2]
b. 6 Aug 1718 d. 20 Apr 1740
9
Thomas Petty
[1.2.6.5.1.3.2.2.3]
b. 5 Feb 1721 d. Aft 1751
9
John Petty
[1.2.6.5.1.3.2.2.4]
b. 23 Mar 1725 d. 17 Aug 1747
9
Mary Petty
[1.2.6.5.1.3.2.2.5]
b. 10 Mar 1729
9
Sarah Petty
[1.2.6.5.1.3.2.2.6]
b. 9 Sep 1732
9
Ruth Petty
[1.2.6.5.1.3.2.2.7]
b. 30 Jun 1742
8
Thomas Petty
[1.2.6.5.1.3.2.3]
b. 1692 d. 9 Nov 1716
8
Ruth Petty
[1.2.6.5.1.3.2.4]
b. Abt 1694 d. 15 Sep 1738
8
John Petty
[1.2.6.5.1.3.2.5]
b. 1696 d. 4 Sep 1716
8
Deliverance Petty
[1.2.6.5.1.3.2.6]
b. 1698 d. 21 Aug 1802
7
Susanna Porter
[1.2.6.5.1.3.3]
b. 2 Jun 1665 bur. 1761
7
Sergeant John Porter
[1.2.6.5.1.3.4]
b. 2 Jul 1667 d. 22 May 1723
7
Samuel Byram Porter
[1.2.6.5.1.3.5]
b. 20 Mar 1670 d. 31 Aug 1725
7
Nicholas Porter
[1.2.6.5.1.3.6]
b. 11 Apr 1672 d. 31 Dec 1773
7
Lieutenant Ebenezer Porter
[1.2.6.5.1.3.7]
b. Abt 1674 d. 1763
7
Ruth Porter
[1.2.6.5.1.3.8]
b. 18 Sep 1676 d. Aft 1739
7
Sarah Porter
[1.2.6.5.1.3.9]
b. 1680 d. 3 Mar 1741
6
Nicholas Byram
[1.2.6.5.1.4]
b. 1640 d. 20 Sep 1727
6
Mary Byram
[1.2.6.5.1.5]
b. 16 Sep 1646 d. Aft 1709
6
Susanna Byram
[1.2.6.5.1.6]
b. 1648 d. 12 Mar 1742
5
Joseph Shaw
[1.2.6.5.2]
b. 14 Mar 1618 d. 13 Dec 1653
5
Grace Shaw
[1.2.6.5.3]
b. 15 Aug 1621 d. 21 Aug 1698
5
Martha Shaw
[1.2.6.5.4]
b. 1 Dec 1623 d. 31 Mar 1625
5
Abigail Shaw
[1.2.6.5.5]
b. 1626
5
Maria "Mary" Shaw
[1.2.6.5.6]
b. 18 Jun 1626 d. 25 Mar 1658
5
John Shaw
[1.2.6.5.7]
b. 2 Mar 1629 d. 30 Jul 1701
2
Richard Swift
[1.3]
b. 1532 d. 1592
2
Hugh Swift
[1.4]
b. 1534 d. 1594
2
Ann Swift
[1.5]
b. 1535 d. 10 Mar 1576
Richard Jessup
b. 1530 d. 26 Nov 1580
3
William Jessup
[1.5.1]
b. 1562 d. 8 Sep 1630
3
Richard Jessup
[1.5.2]
b. 1563 d. 9 Jul 1594
3
Margaret Jessup
[1.5.3]
b. 1565 d. Abt 1616
3
Francis Jessup
[1.5.4]
b. 13 Nov 1569 d. Aft 1624
Frances White
b. 1585 d. Jul 1637
4
John Jessup
[1.5.4.1]
b. 1602 d. Feb 1638
4
Edward Jessup
[1.5.4.2]
b. 1607 d. 1666
4
Simon Jessup
[1.5.4.3]
b. 1610
3
Marie Jessup
[1.5.5]
b. 20 May 1571
3
Susan Jessup
[1.5.6]
b. 1575 d. 1675
2
John Swift
[1.6]
b. 1536 d. 1596
2
Henry Swift
[1.7]
b. 1538 d. 1598