Home Page
|
What's New
|
Photos
|
Histories
|
Headstones
|
Reports
|
Surnames
Search
First Name:
Last Name:
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Suomalainen
Svenska
Dorothy Cotton
Abt 1605 - 1694 (89 years)
Submit Photo / Document
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Submit Photo / Doc
Worksheet
Family
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Dorothy Cotton
[1]
b. Abt 1605 d. 1694
Reverend Henry Smith
b. 1599 d. 9 Aug 1648
2
Sarah Smith
[1.1]
b. 1621 d. 11 Mar 1697
Roger Eastman
b. 4 Apr 1610 d. 16 Dec 1694
3
John Eastman
[1.1.1]
b. 9 Jan 1640 d. 25 Mar 1720
+
Hannah Helie
b. Abt 1644 d. 1667
Mary Boynton
b. 23 May 1648 d. 28 Jul 1727
4
Hannah Eastman
[1.1.1.1]
b. 23 Nov 1673 d. 18 Dec 1673
4
John Eastman, Jr
[1.1.1.2]
b. 24 Aug 1675 d. 1740
Huldah Kingsbury
b. 16 Aug 1680
5
Hannah Eastman
[1.1.1.2.1]
b. 16 May 1698 d. 29 Aug 1739
Samuel George
b. 26 Dec 1696 d. 1725
6
Elisabeth George
[1.1.1.2.1.1]
b. 27 Apr 1726 d. 15 Jul 1749
Simeon Bartlett
b. 17 Jun 1727 d. 13 Mar 1798
7
Elizabeth Bartlett
[1.1.1.2.1.1.1]
b. 7 Jul 1749
6
Mehetabel George
[1.1.1.2.1.2]
b. 7 Feb 1728
6
Tabothy George
[1.1.1.2.1.3]
b. 17 Apr 1731
6
Joseph George
[1.1.1.2.1.4]
b. 1733 d. 11 Mar 1808
Mary Anna Favor
b. 11 Jul 1727 d. 7 Jun 1821
7
Charles George
[1.1.1.2.1.4.1]
b. 10 Jul 1757
+
Miss Worthen
b. Abt 1761
7
Hannah George
[1.1.1.2.1.4.2]
b. 19 Oct 1758 d. 19 Apr 1816
Oliver Cromwell Johnson
b. 23 Mar 1757 d. 23 Apr 1816
8
Sally Johnson
[1.1.1.2.1.4.2.1]
b. 17 Jan 1791
William Yelverton Probart
b. 1785
9
Almyra A Probart
[1.1.1.2.1.4.2.1.1]
b. 1813 d. 1854
John Berry McFerrin
b. 15 Jun 1807 d. 10 May 1887
10
Daughter McFerrin
[1.1.1.2.1.4.2.1.1.1]
b. 1836 d. 1836
10
Sarah Jane McFerrin
[1.1.1.2.1.4.2.1.1.2]
b. 1842
James Douglas Anderson
b. 14 Oct 1824 d. 16 Mar 1902
11
John Mcferrin Anderson
[1.1.1.2.1.4.2.1.1.2.1]
b. 20 Jun 1862 d. 30 Dec 1933
11
William Wade Anderson
[1.1.1.2.1.4.2.1.1.2.2]
b. 19 May 1865 d. 18 Apr 1950
11
Douglas Anderson
[1.1.1.2.1.4.2.1.1.2.3]
b. 10 Jun 1867 d. 8 Oct 1948
11
Walter Leake Anderson
[1.1.1.2.1.4.2.1.1.2.4]
b. 4 Dec 1869 d. 9 Sep 1959
11
Ewell Avery Anderson
[1.1.1.2.1.4.2.1.1.2.5]
b. 31 Dec 1871 d. 26 Nov 1899
11
Mary Anderson
[1.1.1.2.1.4.2.1.1.2.6]
b. 1873
11
Virginia Lon Anderson
[1.1.1.2.1.4.2.1.1.2.7]
b. 1 Nov 1875 d. 22 Jun 1964
11
Dora Anderson
[1.1.1.2.1.4.2.1.1.2.8]
b. 22 Mar 1878 d. 14 Oct 1902
11
Frank Weakley Anderson
[1.1.1.2.1.4.2.1.1.2.9]
b. 30 Mar 1883
11
Janie Parish Anderson
[1.1.1.2.1.4.2.1.1.2.10]
b. 4 Oct 1886 d. 22 May 1930
10
James William McFerrin
[1.1.1.2.1.4.2.1.1.3]
b. 1846 d. Nov 1880
10
John Anderson McFerrin
[1.1.1.2.1.4.2.1.1.4]
b. Mar 1848
10
Bettie McFerrin
[1.1.1.2.1.4.2.1.1.5]
b. Abt 1850 d. Jun 1854
10
Almyra McFerrin
[1.1.1.2.1.4.2.1.1.6]
b. Abt 1854
Augustus Payton Sowell
b. 2 Mar 1849 bur. 3 Sep 1932
11
Fannie McFerrin Sowell
[1.1.1.2.1.4.2.1.1.6.1]
b. Abt 1880
8
Clarissa Harlow Johnson
[1.1.1.2.1.4.2.2]
b. 14 Feb 1789 d. 2 May 1836
Daniel Sanger
b. 3 Jul 1765 d. 10 Dec 1840
9
Joanna Sanger
[1.1.1.2.1.4.2.2.1]
b. 25 Oct 1821
Aaron Rice
b. 1816 d. 11 Mar 1888
10
Sarah Frances Rice
[1.1.1.2.1.4.2.2.1.1]
b. 1 Apr 1850
10
Clara S Rice
[1.1.1.2.1.4.2.2.1.2]
b. 27 Feb 1853
10
Alice Olivia Rice
[1.1.1.2.1.4.2.2.1.3]
b. 28 Jul 1857
+
George G Tidsbury
b. 1853
9
George Jedediah Sanger
[1.1.1.2.1.4.2.2.2]
b. 27 Aug 1826
Susan Victoria Bartholomew
b. 10 Feb 1837
10
Sarah Isabel Sanger
[1.1.1.2.1.4.2.2.2.1]
b. 1 Jan 1865
Benjamin Francis Richardson
b. 22 Aug 1863 d. 15 Feb 1916
11
George Sanger Richardson
[1.1.1.2.1.4.2.2.2.1.1]
b. 1894
10
Ruth L Sanger
[1.1.1.2.1.4.2.2.2.2]
b. 1 Jan 1865
8
Hannah Johnson
[1.1.1.2.1.4.2.3]
b. 3 Feb 1782
David Crockett Snow
b. 1791 d. 1835
9
Hannah Amanda Snow
[1.1.1.2.1.4.2.3.1]
b. Abt 1812
+
Henry M Stratton
b. 1812 d. 5 Sep 1831
9
Mary Ann Snow
[1.1.1.2.1.4.2.3.2]
b. Abt 1814
Madison Stratton
b. Abt 1813 d. 15 Dec 1898
10
Anthony M. Stratton
[1.1.1.2.1.4.2.3.2.1]
b. 1835 d. 2 Nov 1835
10
Amanda Elizabeth Stratton
[1.1.1.2.1.4.2.3.2.2]
b. Abt 1837 d. 18 Jul 1920
Hampton Johnson Cheney
b. 2 Jun 1836 d. 12 Sep 1927
11
Mary Cheney
[1.1.1.2.1.4.2.3.2.2.1]
b. 24 Sep 1865
11
Hampton Johnson Cheney
[1.1.1.2.1.4.2.3.2.2.2]
b. 5 Oct 1867
11
Lenora Cheney
[1.1.1.2.1.4.2.3.2.2.3]
b. 12 Feb 1871
11
Madeline S Cheney
[1.1.1.2.1.4.2.3.2.2.4]
b. 28 Oct 1873
10
David Thomas Stratton
[1.1.1.2.1.4.2.3.2.3]
b. 18 Dec 1838 d. 6 Nov 1896
Agnes F Taylor
b. Abt 1844
11
Sallie Stratton
[1.1.1.2.1.4.2.3.2.3.1]
b. Abt 1861
11
John Taylor Stratton
[1.1.1.2.1.4.2.3.2.3.2]
b. Abt 1867
Katie C Gray
b. 5 Mar 1867 d. 18 Nov 1934
12
Annie S Stratton
[1.1.1.2.1.4.2.3.2.3.2.1]
b. 1898
12
Mary W Stratton
[1.1.1.2.1.4.2.3.2.3.2.2]
b. 1899
11
M T Stratton
[1.1.1.2.1.4.2.3.2.3.3]
b. Abt 1869
11
Agnes Walker Stratton
[1.1.1.2.1.4.2.3.2.3.4]
b. Abt 1878
10
William Oliver Stratton
[1.1.1.2.1.4.2.3.2.4]
b. 16 Oct 1840 d. 6 Oct 1908
Elizabeth T Hall
b. Abt 1846
11
Carrie M Stratton
[1.1.1.2.1.4.2.3.2.4.1]
b. 16 Dec 1866
11
Alexander Stratton
[1.1.1.2.1.4.2.3.2.4.2]
b. Abt 1870
11
Walter M Stratton
[1.1.1.2.1.4.2.3.2.4.3]
b. 1873
Elizabeth Trevin
b. 1876
12
Nell Stratton
[1.1.1.2.1.4.2.3.2.4.3.1]
b. 1901
11
Frank William Stratton
[1.1.1.2.1.4.2.3.2.4.4]
b. Aug 1874 d. 9 Jun 1896
Davie Lou Pursley
b. Oct 1875
12
Carrie Hall Stratton
[1.1.1.2.1.4.2.3.2.4.4.1]
b. 22 Sep 1898 d. 5 Aug 1977 [
=>
]
12
Susie B Stratton
[1.1.1.2.1.4.2.3.2.4.4.2]
b. 1901 d. 2000
12
William P Stratton
[1.1.1.2.1.4.2.3.2.4.4.3]
b. 1903 d. Feb 1974
12
Nina Stratton
[1.1.1.2.1.4.2.3.2.4.4.4]
b. 1904 d. Apr 1987
10
Catherine Stratton
[1.1.1.2.1.4.2.3.2.5]
b. Abt 1844
10
Madison Stratton
[1.1.1.2.1.4.2.3.2.6]
b. Abt 1846
+
Ella A McKennie
b. Abt 1846
10
George Stratton
[1.1.1.2.1.4.2.3.2.7]
b. Abt 1849
+
Louise L Lanier
b. 1850
10
Benjamin Franklin Stratton
[1.1.1.2.1.4.2.3.2.8]
b. 1853
Mary Elizabeth Garrett
b. Oct 1862
11
Mary Margaret Stratton
[1.1.1.2.1.4.2.3.2.8.1]
b. 4 Oct 1884
9
Oliver William Snow
[1.1.1.2.1.4.2.3.3]
b. Abt 1816
9
Anthony J Snow
[1.1.1.2.1.4.2.3.4]
b. 1819 d. 1 Jun 1853
Catherine Stratton
b. 18 Feb 1818 d. Aft 1851
10
James Snow
[1.1.1.2.1.4.2.3.4.1]
b. 1842
Laura
b. 1846
11
Kaley Snow
[1.1.1.2.1.4.2.3.4.1.1]
b. 1869
11
Lula Snow
[1.1.1.2.1.4.2.3.4.1.2]
b. 1874
10
Susan E Snow
[1.1.1.2.1.4.2.3.4.2]
b. 1844
Marcellus M Gee
b. 1842
11
Kate Gee
[1.1.1.2.1.4.2.3.4.2.1]
b. 1866
11
Jennie Gee
[1.1.1.2.1.4.2.3.4.2.2]
b. 1868
10
Mary Snow
[1.1.1.2.1.4.2.3.4.3]
b. 1846
Thomas O Morris
b. 2 Aug 1845 d. 8 Nov 1924
11
Henry Snow Morris
[1.1.1.2.1.4.2.3.4.3.1]
b. 1867
Mary Emma Lackey
b. 1874
12
Thomas O Morris
[1.1.1.2.1.4.2.3.4.3.1.1]
b. 1898
12
James L Morris
[1.1.1.2.1.4.2.3.4.3.1.2]
b. 1902 d. Jan 1973
11
Edwin Lanier Morris
[1.1.1.2.1.4.2.3.4.3.2]
b. 1869
+
Annie M
b. Apr 1869
11
Thomas O Morris, Jr
[1.1.1.2.1.4.2.3.4.3.3]
b. 1872
11
Katherine Morris
[1.1.1.2.1.4.2.3.4.3.4]
b. 1873
11
Kindred Jackson Morris
[1.1.1.2.1.4.2.3.4.3.5]
b. 1875
10
Thomas A Snow
[1.1.1.2.1.4.2.3.4.4]
b. 1850
Susan W Graves
b. Jun 1852 d. 2 Jan 1930
11
Nina Elizabeth Snow
[1.1.1.2.1.4.2.3.4.4.1]
b. 17 Jan 1881 d. 8 May 1974
+
James Leonidas Foust
b. 9 Dec 1867 d. 1944
10
Jennie Snow
[1.1.1.2.1.4.2.3.4.5]
b. 1851
8
Elizabeth Johnson
[1.1.1.2.1.4.2.4]
b. 2 Jul 1783
Isaac Fiske
b. 26 May 1782 d. 3 Dec 1846
9
Moses Madison Fiske
[1.1.1.2.1.4.2.4.1]
b. Abt 1804 d. 5 Feb 1888
Harriet Herring
b. 21 Jan 1807 d. 10 May 1893
10
George Herring Fiske
[1.1.1.2.1.4.2.4.1.1]
b. 26 Feb 1832 d. 5 Dec 1895
Angie W Annett
b. 1832 d. Aft May 1872
11
Effie Fiske
[1.1.1.2.1.4.2.4.1.1.1]
b. 25 Jan 1861 d. Aft Jan 1894
Arthur H Lawrence
b. 24 Nov 1856
12
Ella May Lawrence
[1.1.1.2.1.4.2.4.1.1.1.1]
b. 23 Dec 1885
12
William Arthur Lawrence
[1.1.1.2.1.4.2.4.1.1.1.2]
b. 26 Apr 1887
12
Edith Willena Lawrence
[1.1.1.2.1.4.2.4.1.1.1.3]
b. 2 Jul 1890
12
Edward Wells Lawrence
[1.1.1.2.1.4.2.4.1.1.1.4]
b. 17 Jun 1892
12
Harold Fisk Lawrence
[1.1.1.2.1.4.2.4.1.1.1.5]
b. 21 Jan 1894
11
S Wilbur Fiske
[1.1.1.2.1.4.2.4.1.1.2]
b. 1 May 1872
10
Winslow Johnson Fiske
[1.1.1.2.1.4.2.4.1.2]
b. 18 Feb 1834 d. 14 Jan 1894
10
Harriet Augusta Fiske
[1.1.1.2.1.4.2.4.1.3]
b. 29 May 1836 d. Bef 1940
10
Captain John Murray Fiske
[1.1.1.2.1.4.2.4.1.4]
b. 28 Sep 1838 d. 3 May 1896
10
Marie Antionette Fiske
[1.1.1.2.1.4.2.4.1.5]
b. 1840 d. Aft 1870
10
Ellen Louisa Fiske
[1.1.1.2.1.4.2.4.1.6]
b. 6 May 1843 d. 6 Jun 1868
10
Andrew J Fiske
[1.1.1.2.1.4.2.4.1.7]
b. 8 Jun 1845 d. 5 Mar 1895
10
Seth Herring Fiske
[1.1.1.2.1.4.2.4.1.8]
b. 11 Apr 1848 d. 5 Sep 1870
9
Oliver J Fiske
[1.1.1.2.1.4.2.4.2]
b. Abt 1805 d. 8 Jan 1886
9
Charles C Fiske
[1.1.1.2.1.4.2.4.3]
b. 23 Feb 1807
9
Thomas Fiske
[1.1.1.2.1.4.2.4.4]
b. Abt 1809 d. Jan 1893
9
Ebenezer W Fiske
[1.1.1.2.1.4.2.4.5]
b. Abt 1812 d. 27 Aug 1883
8
Parthena Johnson
[1.1.1.2.1.4.2.5]
b. 8 Aug 1785 d. 25 Jan 1820
8
Gabrilla Johnson
[1.1.1.2.1.4.2.6]
b. 27 Feb 1786 d. 11 Jan 1867
8
Frances Fanny Johnson
[1.1.1.2.1.4.2.7]
b. Abt 1789
8
Oliver C Johnson
[1.1.1.2.1.4.2.8]
b. 29 Apr 1792
8
Windlow Penkard Johnson
[1.1.1.2.1.4.2.9]
b. 22 Mar 1794
8
Hannah Johnson
[1.1.1.2.1.4.2.10]
b. Abt 1795
8
Anthony Wayne Johnson
[1.1.1.2.1.4.2.11]
b. 10 Jul 1797 d. 15 May 1888
7
Betsey George
[1.1.1.2.1.4.3]
b. 1759
7
Samuel George
[1.1.1.2.1.4.4]
b. 1761 d. 4 May 1845
7
Ezra George
[1.1.1.2.1.4.5]
b. 14 Apr 1763
7
Abigail George
[1.1.1.2.1.4.6]
b. 16 Dec 1764
7
Elijah George
[1.1.1.2.1.4.7]
b. Abt 1765 d. 15 Jan 1843
7
Daniel George
[1.1.1.2.1.4.8]
b. Abt 1768 d. 11 Sep 1841
7
Joseph George
[1.1.1.2.1.4.9]
b. 1770 d. 22 Mar 1843
7
Mehetabel George
[1.1.1.2.1.4.10]
b. Abt 1772 d. 1827
7
Rhoda George
[1.1.1.2.1.4.11]
b. Abt 1774 d. 14 Dec 1826
7
Lydia George
[1.1.1.2.1.4.12]
b. Abt 1776
7
Nathan George
[1.1.1.2.1.4.13]
b. Abt 1777
7
Benjamin George
[1.1.1.2.1.4.14]
b. Abt 1778
5
Mary Eastman
[1.1.1.2.2]
b. 19 Jan 1700 d. Apr 1754
5
John Eastman
[1.1.1.2.3]
b. 27 Dec 1701 d. 1741
5
Samuel Eastman
[1.1.1.2.4]
b. 18 Aug 1705 d. 28 Sep 1706
5
Roger Eastman
[1.1.1.2.5]
b. 9 May 1707 d. Aft 1739
5
Elizabeth Eastman
[1.1.1.2.6]
b. 3 Mar 1709 d. 1780
5
Mehitable Eastman
[1.1.1.2.7]
b. 25 Jul 1711 d. 16 Oct 1721
5
Hulda Eastman
[1.1.1.2.8]
b. 7 Oct 1714
5
Tabitha Eastman
[1.1.1.2.9]
b. 20 Jan 1722 d. 29 Mar 1729
4
Zachariah Eastman
[1.1.1.3]
b. 24 Oct 1679 d. 18 Nov 1732
4
Roger Eastman
[1.1.1.4]
b. 26 Feb 1682 d. Apr 1743
4
Elizabeth Eastman
[1.1.1.5]
b. 26 Sep 1685
4
Thomas Eastman
[1.1.1.6]
b. 14 Feb 1688 d. 27 Aug 1691
4
Thomas Eastman
[1.1.1.7]
b. 1691
4
Joseph Eastman
[1.1.1.8]
b. 23 Jun 1692 d. 8 Oct 1761
3
Nathaniel Eastman
[1.1.2]
b. 18 Mar 1643 d. 30 Nov 1709
3
Philip Eastman
[1.1.3]
b. 20 Oct 1644 d. 20 Oct 1714
Mary Barnard
b. 22 Sep 1645 d. 11 Jun 1724
4
Hannah Eastman
[1.1.3.1]
b. 5 Nov 1679 d. 15 Jul 1756
4
Ebenezer Eastman
[1.1.3.2]
b. 17 Feb 1681 d. 28 Jul 1748
4
Abigail Eastman
[1.1.3.3]
b. 29 May 1689 d. 21 Feb 1759
John Marsh
b. 1 Sep 1681 d. 8 Sep 1727
5
Samuel Marsh
[1.1.3.3.1]
b. 19 Nov 1713
5
Mary Marsh
[1.1.3.3.2]
b. 9 Dec 1716 d. 8 Feb 1738
Aaron Lyon
b. 4 Jan 1706 d. 24 May 1746
6
Aaron Lyon
[1.1.3.3.2.1]
b. 1730 d. 7 Feb 1806
5
John Marsh
[1.1.3.3.3]
b. 8 Oct 1718 d. 1802
5
Abigail Marsh
[1.1.3.3.4]
b. 26 Dec 1720 d. 21 Jun 1804
Thomas Emerson
b. 1723 d. 13 Oct 1796
6
John Emerson
[1.1.3.3.4.1]
b. 4 Oct 1763
6
Phebe Emerson
[1.1.3.3.4.2]
b. 14 Nov 1759
6
Eunice Emerson
[1.1.3.3.4.3]
b. 9 Sep 1761 d. 1786
6
Daniel Emerson
[1.1.3.3.4.4]
b. 5 Apr 1753 d. Oct 1822
6
Mary Emerson
[1.1.3.3.4.5]
b. 24 Feb 1757
6
Enoch Emerson
[1.1.3.3.4.6]
b. 26 Feb 1755 d. 13 May 1835
6
Abigail Emerson
[1.1.3.3.4.7]
b. 25 Apr 1756 d. 15 Sep 1804
6
Asa Emerson
[1.1.3.3.4.8]
b. 19 Aug 1749
6
Esther Emerson
[1.1.3.3.4.9]
b. 14 Jun 1751 d. 10 Feb 1825
5
Hannah Marsh
[1.1.3.3.5]
b. 18 Mar 1722
5
Sarah Marsh
[1.1.3.3.6]
b. 13 Mar 1724
5
Esther Marsh
[1.1.3.3.7]
b. 28 Jun 1726 d. 14 Mar 1802
Jacob Taft
b. 22 Apr 1725 d. 15 Mar 1802
6
Esther Taft
[1.1.3.3.7.1]
b. 9 Jan 1747 d. 3 Feb 1834
James Taft
b. 9 Apr 1738 d. 14 Jan 1826
7
Lucy Taft
[1.1.3.3.7.1.1]
b. 22 Nov 1769 d. 29 Jul 1845
Ebenezer Winslow
b. 21 Jan 1772 d. 21 Feb 1841
8
Albert Winslow
[1.1.3.3.7.1.1.1]
b. 24 Jul 1797
Sarah Gardner
b. 25 Jul 1803 d. 23 Sep 1840
9
Martha Maria Winslow
[1.1.3.3.7.1.1.1.1]
b. 12 Mar 1826 d. 16 Mar 1842
9
Preston Willard Winslow
[1.1.3.3.7.1.1.1.2]
b. 13 Nov 1828
Lucy Weatherbee
b. 16 Jul 1829 d. 8 Nov 1859
10
Mary Charlena Winslow
[1.1.3.3.7.1.1.1.2.1]
b. 22 Apr 1858
+
Maria Fuller
b. 12 Apr 1841
9
Mary Augusta Allen Winslow
[1.1.3.3.7.1.1.1.3]
b. 14 Sep 1831
+
Charles Warner
b. Abt 1830
9
John Alvin Winslow
[1.1.3.3.7.1.1.1.4]
b. 3 Jul 1834
9
Jasper Ross Winslow
[1.1.3.3.7.1.1.1.5]
b. 7 Apr 1837 d. 25 Oct 1841
9
Sarah Adaline Winslow
[1.1.3.3.7.1.1.1.6]
b. 20 Dec 1839 d. 9 Dec 1841
Sylvia Babbit
b. 27 Jan 1814
9
Jasper Albert Winslow
[1.1.3.3.7.1.1.1.7]
b. 15 Apr 1842 d. 14 Oct 1864
8
Claramond Winslow
[1.1.3.3.7.1.1.2]
b. 10 Feb 1799 d. 27 Apr 1834
John Hathaway
b. 22 May 1797
9
Son Hathaway
[1.1.3.3.7.1.1.2.1]
b. Apr 1828 d. 14 Apr 1828
9
Francis Ebenezer Hathaway
[1.1.3.3.7.1.1.2.2]
b. 9 Mar 1829
Lydia Carter
b. 24 Mar 1832
10
Hattie Carter Hathaway
[1.1.3.3.7.1.1.2.2.1]
b. 10 Jan 1865 d. 30 Oct 1958
Ezra Hyde Alden
b. 26 Jan 1866
11
Esther Hyde Alden
[1.1.3.3.7.1.1.2.2.1.1]
b. 31 Mar 1893
11
Olive Hathaway Alden
[1.1.3.3.7.1.1.2.2.1.2]
b. 12 Sep 1896
+
Roy Frank Larson
b. 1896
11
Philip Meriam Alden
[1.1.3.3.7.1.1.2.2.1.3]
b. 5 Mar 1900
+
Emma Louise Snow
b. 29 Sep 1899
9
Catherine Elizabeth Hathaway
[1.1.3.3.7.1.1.2.3]
b. 18 Feb 1833
9
George H Hathaway
[1.1.3.3.7.1.1.2.4]
b. 13 Aug 1839
Abigail F Pomeroy
b. Abt 1843 d. 9 Feb 1891
10
Charles Edward Hathaway
[1.1.3.3.7.1.1.2.4.1]
b. 23 Oct 1866
8
Alvin Winslow
[1.1.3.3.7.1.1.3]
b. 27 Aug 1802 d. 9 Oct 1803
8
Paulina Maria Winslow
[1.1.3.3.7.1.1.4]
b. 27 May 1805
+
Austin Crosby
b. 10 Mar 1805 d. 13 Jun 1868
8
Lucy Emma Winslow
[1.1.3.3.7.1.1.5]
b. 17 Feb 1808 d. 20 Feb 1870
+
Matthew Henry McClary
b. 10 Mar 1801
7
Zilpha Taft
[1.1.3.3.7.1.2]
b. 1 Jul 1772 d. 24 Feb 1848
Nathan Fisher
b. 25 Jun 1770 d. 21 Mar 1847
8
Elias Fisher
[1.1.3.3.7.1.2.1]
b. 10 Jul 1796
8
Elise Fisher
[1.1.3.3.7.1.2.2]
b. 10 Jul 1796
8
Josiah Fisher
[1.1.3.3.7.1.2.3]
b. 26 Feb 1798 d. 11 Apr 1799
8
Josiah Fisher
[1.1.3.3.7.1.2.4]
b. 1 Dec 1801
8
Rachel Adaline Fisher
[1.1.3.3.7.1.2.5]
b. 29 Jan 1804
+
Moses Daniels Southwick
8
Mary Caroline Fisher
[1.1.3.3.7.1.2.6]
b. 22 Mar 1806
8
Nathan Fisher
[1.1.3.3.7.1.2.7]
b. 21 Mar 1811
7
Irena Taft
[1.1.3.3.7.1.3]
b. 25 Oct 1774 d. 29 May 1790
7
Ezekial Taft
[1.1.3.3.7.1.4]
b. 21 Jan 1777 d. 24 Apr 1841
+
Olive Thayer
b. 10 Aug 1782 d. 1865
7
James Taft
[1.1.3.3.7.1.5]
b. 13 Jun 1780
7
Luke Taft
[1.1.3.3.7.1.6]
b. 3 Jun 1783
Nancy Wood
b. 6 Feb 1787 d. 6 May 1859
8
Clarissa Wood Taft
[1.1.3.3.7.1.6.1]
b. 3 May 1810 d. 1889
Caleb Chapin
b. 6 Feb 1806 d. 27 Sep 1883
9
Eunice Chapin
[1.1.3.3.7.1.6.1.1]
b. 1 May 1832 d. 29 Sep 1920
Samuel Mills Capron
b. 15 May 1832 d. 4 Jan 1874
10
Helen Maria Capron
[1.1.3.3.7.1.6.1.1.1]
b. 26 Mar 1858 d. 6 Jan 1863
10
Alice Louise Capron
[1.1.3.3.7.1.6.1.1.2]
b. 26 Mar 1862 d. 13 Jan 1863
10
Clara D Capron
[1.1.3.3.7.1.6.1.1.3]
b. 4 Aug 1864
10
Bertha C Capron
[1.1.3.3.7.1.6.1.1.4]
b. 16 Mar 1868
Samuel Bostwick Robbins
b. 15 Oct 1867 d. 1948
11
Samuel Capron Robbins
[1.1.3.3.7.1.6.1.1.4.1]
b. 21 May 1902
10
William Cargill Capron
[1.1.3.3.7.1.6.1.1.5]
b. 27 Jul 1869
Adalaide Griswold
b. Abt 1873
11
Robert Griswold Capron
[1.1.3.3.7.1.6.1.1.5.1]
b. 20 Nov 1895
9
Ezra Wood Chapin
[1.1.3.3.7.1.6.1.2]
b. 7 Jun 1836 d. 31 Mar 1909
Ellen Frances Cooper
b. 30 Dec 1835
10
Janet Chapin
[1.1.3.3.7.1.6.1.2.1]
b. 28 May 1870
9
Edwin Chapin
[1.1.3.3.7.1.6.1.3]
b. 7 Jun 1836 d. 27 Sep 1836
8
Moses Taft
[1.1.3.3.7.1.6.2]
b. 26 Jan 1812
Sylvia Ann Wheelock
b. 3 Feb 1815 d. 3 Oct 1855
9
Sarah Wood Taft
[1.1.3.3.7.1.6.2.1]
b. 6 Jan 1838
Lewis Henry Murdock
b. 17 Mar 1835 d. 25 Mar 1916
10
Herbert Taft Murdock
[1.1.3.3.7.1.6.2.1.1]
b. 11 Sep 1865 d. 29 Oct 1916
Cora Talbot Gould
b. 1 Oct 1863
11
Marjorie Taft Murdock
[1.1.3.3.7.1.6.2.1.1.1]
b. 6 Feb 1894 d. 21 Mar 1977
+
Floyd Arthur Sears
b. 21 Oct 1891
11
Helen Murdock
[1.1.3.3.7.1.6.2.1.1.2]
b. 14 Jun 1903 d. Dec 1977
+
Daniel Rogers Pinkham
b. 15 Jan 1899 d. Aug 1976
10
Edgar Wheelock Murdock
[1.1.3.3.7.1.6.2.1.2]
b. 1 Feb 1869 d. 13 Jun 1904
9
Susan Hortense Taft
[1.1.3.3.7.1.6.2.2]
b. 5 Jan 1843
9
Luke Herbert Taft
[1.1.3.3.7.1.6.2.3]
b. 9 Nov 1846
+
Helen Eugenia Bechet
8
Sarah Taft
[1.1.3.3.7.1.6.3]
b. 15 Jan 1815 d. 24 Dec 1898
Amariah Albee Wood
b. 2 Nov 1802 d. 14 Jun 1871
9
Sarah A Wood
[1.1.3.3.7.1.6.3.1]
b. May 1837 d. 26 Sep 1837
9
Samuel Taft Wood
[1.1.3.3.7.1.6.3.2]
b. 4 Oct 1841 d. Jun 1925
+
Olive DeWilton Seagrave
b. 17 Jul 1842 d. 7 Aug 1862
Mary E Rawson
b. 11 Sep 1845
10
Eva Gertrude Wood
[1.1.3.3.7.1.6.3.2.1]
b. 29 May 1865
+
Henry Arthur Wilcox
b. 11 Jun 1860
10
Merritt D Wood
[1.1.3.3.7.1.6.3.2.2]
b. 2 Sep 1873
9
Mary Baylies Wood
[1.1.3.3.7.1.6.3.3]
b. 29 Apr 1847 d. 9 Sep 1847
9
Anna I Wood
[1.1.3.3.7.1.6.3.4]
b. 18 Aug 1848 d. 1919
8
Irene Taft
[1.1.3.3.7.1.6.4]
b. 19 Sep 1816 d. 26 Jan 1900
Silas Mandeville Wheelock
b. 11 Nov 1817 d. 18 Oct 1901
9
Ellen Maria Wheelock
[1.1.3.3.7.1.6.4.1]
b. 2 Sep 1842 d. 1871
9
Eugene Augustus Wheelock
[1.1.3.3.7.1.6.4.2]
b. 15 Feb 1846 d. 14 Sep 1912
Sarah Smith Taft
b. 17 Apr 1846
10
Silas Mandeville Wheelock
[1.1.3.3.7.1.6.4.2.1]
b. 10 Mar 1871 d. 22 Jun 1937
Ruth Elizabeth Shaw
b. 10 Mar 1876
11
Sarah Taft Wheelock
[1.1.3.3.7.1.6.4.2.1.1]
b. 31 Aug 1905 d. 11 Jan 1909
11
Silas Mandeville Wheelock, Jr
[1.1.3.3.7.1.6.4.2.1.2]
b. 10 Jun 1917 d. Aug 1978
10
Ellen Maria Wheelock
[1.1.3.3.7.1.6.4.2.2]
b. 20 Mar 1873 d. 12 Mar 1954
10
Mary Taft Wheelock
[1.1.3.3.7.1.6.4.2.3]
b. 8 Aug 1875 d. 21 Jul 1957
10
Irene Taft Wheelock
[1.1.3.3.7.1.6.4.2.4]
b. 7 Apr 1881 d. 2 Jan 1963
10
Henry Arnold Wheelock
[1.1.3.3.7.1.6.4.2.5]
b. 27 Aug 1883 d. 12 Jul 1954
+
Caroline Harper
9
Alice Augusta Wheelock
[1.1.3.3.7.1.6.4.3]
b. 22 Jan 1849 d. Sep 1891
9
Arthur Wheelock
[1.1.3.3.7.1.6.4.4]
b. 26 Mar 1851 d. 23 Sep 1927
Emogene Atchinson
b. 22 Sep 1851 d. 12 Apr 1898
10
Stanley H Wheelock
[1.1.3.3.7.1.6.4.4.1]
b. 15 Jul 1879
Harriet F Tobey
b. 13 Sep 1887
11
Philip Stanley Wheelock
[1.1.3.3.7.1.6.4.4.1.1]
b. 31 Aug 1916 d. 14 Apr 1997
11
Walter Tobey Wheelock
[1.1.3.3.7.1.6.4.4.1.2]
b. 4 Jul 1923 d. 15 Oct 1979
10
Annie Atchinan Wheelock
[1.1.3.3.7.1.6.4.4.2]
b. 15 Jan 1887 d. 5 Oct 1918
+
Harriet E Fuller
b. 1845
9
Henry Wheelock
[1.1.3.3.7.1.6.4.5]
b. 14 Jan 1857 d. 13 Nov 1881
+
Jane Goulding Taft
b. 12 Oct 1856 d. 20 Jan 1931
8
Chloe M Taft
[1.1.3.3.7.1.6.5]
b. 5 Feb 1823
Luke Southwick Farnham
b. 20 Jan 1817 d. 23 Aug 1883
9
Elizabeth Southwick Farnham
[1.1.3.3.7.1.6.5.1]
b. 1852
+
Jerome Prentiss
9
Ella Frances Farnham
[1.1.3.3.7.1.6.5.2]
b. 1855
9
Moses Taft Farnham
[1.1.3.3.7.1.6.5.3]
b. 1858
9
Walter James Farnham
[1.1.3.3.7.1.6.5.4]
b. 1862
8
James Taft
[1.1.3.3.7.1.6.6]
b. 1830
7
Esther Taft
[1.1.3.3.7.1.7]
b. 5 Aug 1786 d. 10 Aug 1858
Fuller Murdock
b. 17 Feb 1781 d. 8 Nov 1857
8
Philena Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.1]
b. 26 Aug 1807 d. 30 Jun 1835
Samuel Merriam
b. Abt 1803
9
George Nison Merriam
[1.1.3.3.7.1.7.1.1]
b. 26 Dec 1834 d. 19 Nov 1903
Ellen Jane Pickering
b. 27 Mar 1836 d. 15 Jan 1911
10
Josephine Louisa Merriam
[1.1.3.3.7.1.7.1.1.1]
b. 29 Oct 1859 d. 14 Mar 1949
10
Nellie Pickering Merriam
[1.1.3.3.7.1.7.1.1.2]
b. 26 Feb 1870 d. 20 Nov 1887
10
Flora N. Merriam
[1.1.3.3.7.1.7.1.1.3]
b. 31 Mar 1872
8
Abba Eliza Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.2]
b. 13 Nov 1808 d. 4 Apr 1834
Pemberton Brown
b. 11 Oct 1801 d. 30 Mar 1870
9
Tarissa Gregory Brown
[1.1.3.3.7.1.7.2.1]
b. 3 Oct 1828 d. 12 Oct 1914
John Conley Fisher
b. 25 May 1818 d. 1 Dec 1898
10
Paulina Agnes Fisher
[1.1.3.3.7.1.7.2.1.1]
b. 2 Dec 1848 d. 2 Oct 1850
10
Elizabeth B Fisher
[1.1.3.3.7.1.7.2.1.2]
b. 25 Jun 1853 d. 5 Nov 1933
Frank P Hammond
b. Oct 1851 d. 24 Feb 1904
11
Albert Chester Hammond
[1.1.3.3.7.1.7.2.1.2.1]
b. 9 Sep 1875 d. 7 May 1947
Grace Louise Hawkins
b. Dec 1872
12
Grace L. Hammond
[1.1.3.3.7.1.7.2.1.2.1.1]
b. Mar 1900
12
Louise Inez Hammond
[1.1.3.3.7.1.7.2.1.2.1.2]
b. 20 May 1902 d. 28 Feb 1993
12
Albert C. Hammond
[1.1.3.3.7.1.7.2.1.2.1.3]
b. 27 Feb 1904 d. 17 Nov 1906
12
Daughter Hammond
[1.1.3.3.7.1.7.2.1.2.1.4]
b. 18 Mar 1907 d. 18 Mar 1907
12
Ronald C. Hammond
[1.1.3.3.7.1.7.2.1.2.1.5]
b. 19 Feb 1913 d. 28 Jul 2001
11
Ethel Pacific Hammond
[1.1.3.3.7.1.7.2.1.2.2]
b. 1 Oct 1883 d. 13 Sep 1947
Claude Warren Perry
b. 1866 d. 10 Oct 1928
12
Warren N Perry
[1.1.3.3.7.1.7.2.1.2.2.1]
b. Abt 1902
12
Vivienne Perry
[1.1.3.3.7.1.7.2.1.2.2.2]
b. 1 Aug 1915 d. 24 Sep 2006
+
Leroy Slade Williams
b. 20 May 1885 d. 15 Jan 1949
+
Edwin W Crocker
b. 1847 d. 12 Nov 1914
10
Alonzo Pemberton Fisher
[1.1.3.3.7.1.7.2.1.3]
b. 11 Dec 1855 d. 21 Feb 1937
Sarah Jane Whipple
b. Abt 1857 d. 3 Jun 1941
11
Ernest Marshall Fisher
[1.1.3.3.7.1.7.2.1.3.1]
b. 15 Nov 1884
Beatrice M Friel
b. 1883 d. Bef 1940
12
Raymond Ernest Fisher
[1.1.3.3.7.1.7.2.1.3.1.1]
b. 30 Sep 1907 d. 19 Jun 1983
12
Beatrice F Fisher
[1.1.3.3.7.1.7.2.1.3.1.2]
b. 6 Aug 1909 d. 9 Nov 1995
12
John R Fisher
[1.1.3.3.7.1.7.2.1.3.1.3]
b. 22 May 1914 d. 26 Jan 2000
11
William Adelbert Fisher
[1.1.3.3.7.1.7.2.1.3.2]
b. 20 Aug 1886
+
Mary L.
b. 1881
11
Alonso Pemberton Fisher, Jr
[1.1.3.3.7.1.7.2.1.3.3]
b. 18 Nov 1888 d. 14 Feb 1892
11
Clarence Albert Fisher
[1.1.3.3.7.1.7.2.1.3.4]
b. 10 Jun 1891 d. Nov 1983
+
Mary E. O'Connell
b. 27 Jul 1895 d. Oct 1984
11
Nathaniel Franklyn Fisher
[1.1.3.3.7.1.7.2.1.3.5]
b. 6 Oct 1895 d. May 1978
+
Myrtle
b. 31 May 1902 d. Nov 1975
11
Lottie Irene Fisher
[1.1.3.3.7.1.7.2.1.3.6]
b. 4 Jan 1898 d. Aug 1991
+
John P. Bildner
b. 1891 d. Aft 1954
11
Alice May Fisher
[1.1.3.3.7.1.7.2.1.3.7]
b. 15 Jul 1901
+
David Raymond Jefferson
b. 1 Jan 1894
10
Ida H. Fisher
[1.1.3.3.7.1.7.2.1.4]
b. 1858
10
Lillian L. Fisher
[1.1.3.3.7.1.7.2.1.5]
b. 2 Oct 1860
10
Malvern Adelbert Fisher
[1.1.3.3.7.1.7.2.1.6]
b. 30 Mar 1863
Isabelle E Crane
b. Apr 1866
11
Goldina Mabel Fisher
[1.1.3.3.7.1.7.2.1.6.1]
b. 15 Dec 1885 d. 8 Sep 1974
11
Adelbert Augustus Fisher
[1.1.3.3.7.1.7.2.1.6.2]
b. 8 Jul 1899 d. Dec 1979
10
Georgene Fisher Gardner
[1.1.3.3.7.1.7.2.1.7]
b. 12 Oct 1864 d. 17 Oct 1942
Herbert Fearing Gardner
b. Sep 1862 d. 9 Jan 1943
11
Sarah Theresa Gardner
[1.1.3.3.7.1.7.2.1.7.1]
b. 15 Sep 1885
+
Wayne Lawrence Randall
b. 22 Jan 1884 d. Mar 1967
11
Eva May Gardner
[1.1.3.3.7.1.7.2.1.7.2]
b. 5 Sep 1887 d. 4 Dec 1963
+
Archie Edward King
b. 15 Jul 1886 d. 6 Dec 1977
11
Lory Tallman Gardner
[1.1.3.3.7.1.7.2.1.7.3]
b. 9 Oct 1895 d. 1951
+
Nancy Marie Hoffman
b. 13 Apr 1900 d. 2 Jul 1987
10
Myrtella Fisher
[1.1.3.3.7.1.7.2.1.8]
b. 30 Jul 1867
9
Josephine Brown
[1.1.3.3.7.1.7.2.2]
b. 29 Jan 1830 d. 16 Jan 1895
William Brainerd Cadwell
b. 2 Sep 1832 d. 1870
10
Abbie Flora Cadwell
[1.1.3.3.7.1.7.2.2.1]
b. 19 Oct 1854 d. 24 Sep 1937
Charles Scott Seagrave
b. 9 Aug 1852 d. 15 Feb 1931
11
Mabel A. Seagrave
[1.1.3.3.7.1.7.2.2.1.1]
b. Aug 1875 d. 1946
Leon L Southwick
b. 18 Aug 1876
12
Marjorie Southwick
[1.1.3.3.7.1.7.2.2.1.1.1]
b. 1898
12
Dorothy Seagrave Southwick
[1.1.3.3.7.1.7.2.2.1.1.2]
b. 10 Aug 1901 d. 31 Jan 1980
11
Florence Carter Seagrave
[1.1.3.3.7.1.7.2.2.1.2]
b. 1 Dec 1877 d. 2 Mar 1948
11
Daughter Seagrave
[1.1.3.3.7.1.7.2.2.1.3]
b. 22 Dec 1879 d. 1883
11
Charles Edwin Seagrave
[1.1.3.3.7.1.7.2.2.1.4]
b. 9 Nov 1883 d. 1956
Laura Linton Tabor
b. 23 Sep 1884 d. 1959
12
Edwin Linton Seagrave
[1.1.3.3.7.1.7.2.2.1.4.1]
b. 1907 d. 1968
12
Gardner C. Seagrave
[1.1.3.3.7.1.7.2.2.1.4.2]
b. 2 Mar 1912 d. 21 Apr 1999
11
Mary Alice Seagrave
[1.1.3.3.7.1.7.2.2.1.5]
b. 11 Jul 1887
11
Frederick William Seagrave
[1.1.3.3.7.1.7.2.2.1.6]
b. 22 Jan 1890
10
Etola Florence Cadwell
[1.1.3.3.7.1.7.2.2.2]
b. 16 Jul 1857 d. 27 Dec 1937
William R Esten, Jr
b. 26 Oct 1857
11
Josephine Esten
[1.1.3.3.7.1.7.2.2.2.1]
b. 14 Sep 1889
9
Adin Ballou Brown
[1.1.3.3.7.1.7.2.3]
b. 14 Nov 1831 d. 19 Apr 1880
9
Edin Ballow Brown
[1.1.3.3.7.1.7.2.4]
b. 14 Nov 1831
9
Abba Eliza Brown
[1.1.3.3.7.1.7.2.5]
b. 30 Jun 1833 d. 19 Oct 1914
Abiel Copelin
b. 22 Jul 1834 d. 8 Jul 1907
10
Arthur A. Copelin
[1.1.3.3.7.1.7.2.5.1]
b. 1859 d. 3 May 1884
10
Herbert A. Copelin
[1.1.3.3.7.1.7.2.5.2]
b. 31 May 1867 d. 14 Aug 1867
8
Moses Taft Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.3]
b. 12 Sep 1810 d. 7 Feb 1883
Dorinda Wood Grout
b. 19 Aug 1810 d. 15 Jan 1888
9
Cyrus Grout Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.3.1]
b. 16 Jun 1833 d. 7 Jun 1913
Sarah Ann Aldrich
b. 3 Apr 1831 d. 1 Mar 1902
10
Son Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.3.1.1]
b. 20 May 1856 d. 20 May 1856
10
Lillian A Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.3.1.2]
b. 17 Apr 1857 d. 7 Dec 1927
+
Frederick William Lackey
b. 4 Aug 1854 d. 24 Jun 1931
10
Bertha Aldrich Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.3.1.3]
b. 15 May 1872 d. 12 Nov 1940
+
James Herbert Farnum
b. 1858 d. 9 Feb 1934
9
Lewis Henry Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.3.2]
b. 17 Mar 1835 d. 25 Mar 1916
Sarah Wood Taft
b. 6 Jan 1838
10
Herbert Taft Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.3.2.1]
b. 11 Sep 1865 d. 29 Oct 1916
Cora Talbot Gould
b. 1 Oct 1863
11
Marjorie Taft Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.3.2.1.1]
b. 6 Feb 1894 d. 21 Mar 1977
+
Floyd Arthur Sears
b. 21 Oct 1891
11
Helen Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.3.2.1.2]
b. 14 Jun 1903 d. Dec 1977
+
Daniel Rogers Pinkham
b. 15 Jan 1899 d. Aug 1976
10
Edgar Wheelock Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.3.2.2]
b. 1 Feb 1869 d. 13 Jun 1904
9
Sarah A Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.3.3]
b. Jul 1837 d. 1 Sep 1838
9
Lucius Walter Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.3.4]
b. 11 Apr 1846 d. 1 Jul 1867
9
Samuel Justin Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.3.5]
b. 13 May 1848 d. 11 May 1910
Mary Brown
b. 1843 d. 11 Apr 1920
10
Lena D M Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.3.5.1]
b. 5 Mar 1871 d. 30 Jun 1871
10
Lewis F Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.3.5.2]
b. 18 May 1873
9
Lyman Wood Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.3.6]
b. 26 Dec 1853 d. Bef 1900
Elizabeth Ann Snowling
b. 16 Jan 1860 d. 17 Aug 1918
10
May A. Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.3.6.1]
b. 1881
+
Cornelius R. Dubois
b. 1881
10
Minnie Idella Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.3.6.2]
b. 19 Jun 1884
8
John Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.4]
b. 9 Sep 1812 d. 13 Sep 1837
8
Charles Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.5]
b. 11 Feb 1815 d. 6 Aug 1869
Mary Ann Weightman
b. 3 Apr 1823 d. 11 May 1895
9
Charles W Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.5.1]
b. 4 Mar 1854 d. 5 Mar 1916
Abba Loretta Wardwell
b. 29 Jan 1849 d. 12 Jun 1929
10
Leroy Eugene Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.5.1.1]
b. 22 Jan 1875
Hattie D Warren
b. 1889 d. Bef 1930
11
Eleanor Weightman Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.5.1.1.1]
b. 30 Aug 1911 d. Apr 1997
11
Sherman W Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.5.1.1.2]
b. 12 Mar 1920 d. 30 Jan 1996
10
Horace Sherman Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.5.1.2]
b. 27 May 1879
Sabra Foster Littlefield
b. 9 Apr 1881 d. 22 Dec 1907
11
Horace S. Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.5.1.2.1]
b. 1898 d. 13 Apr 1899
Lillian May Carlton
b. 24 Feb 1888
11
Horace Carleton Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.5.1.2.2]
b. 13 May 1914 d. 14 Sep 1996
8
Caleb Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.6]
b. 16 Feb 1817 d. 10 May 1892
Maria Howard Emerson
b. 27 Dec 1830 d. 11 Oct 1901
9
Frank Fuller Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.6.1]
b. 18 May 1857 d. 13 Jan 1939
Alice M Gardner
b. Apr 1868
10
Dorothy Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.6.1.1]
b. 27 Nov 1892 d. Jul 1978
10
Edwin Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.6.1.2]
b. 11 Jun 1896 d. Jun 1977
+
Margaret P. B. Labrum
b. 1893
9
Herbert Emerson Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.6.2]
b. 16 Jan 1859 d. 18 Jan 1931
Nancy Sophia Brigham
b. 29 Sep 1862 d. 1 Mar 1943
10
Russell Brigham Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.6.2.1]
b. 7 Sep 1893 d. 20 Feb 1969
10
Phyllis Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.6.2.2]
b. 15 Nov 1895
+
Walter Stephen Coleman
b. 15 May 1891
10
Marjory Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.6.2.3]
b. 1896
9
Eugene Clifford Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.6.3]
b. 24 Nov 1863 d. 13 Sep 1924
+
Elizabeth Howland Hutchinson
b. 7 Dec 1856
9
Carrie Maria Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.6.4]
b. 4 Sep 1865
Edward Augustus Rich
b. 29 Jul 1844 d. Bef 1930
10
Priscilla Augusta Rich
[1.1.3.3.7.1.7.6.4.1]
b. 19 Oct 1898 d. 13 Apr 1899
10
Edward Augustus Rich
[1.1.3.3.7.1.7.6.4.2]
b. 19 May 1900 d. 2 Nov 1982
8
George Taft Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.7]
b. 18 Mar 1819
Abbie Ann Robinson
b. Abt 1825
9
George Thurston Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.7.1]
b. 4 Jul 1846 d. 30 Jan 1933
Arvilla Richardson Thayer
b. 4 Feb 1850 d. 29 Oct 1902
10
Mabel Florence Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.7.1.1]
b. 13 Dec 1875 d. Aft 1944
George Russell Stobbs
b. 7 Feb 1877
11
Russell W. Stobbs
[1.1.3.3.7.1.7.7.1.1.1]
b. 7 Aug 1907 d. 12 Mar 1975
9
Lizzie Green Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.7.2]
b. 2 Sep 1857 d. 3 May 1879
Horace Edward Bigelow
b. 9 Jun 1857
10
Daughter Bigelow
[1.1.3.3.7.1.7.7.2.1]
b. 1879
10
Geraldine Murdock Bigelow
[1.1.3.3.7.1.7.7.2.2]
b. 16 Apr 1879
10
Gretchen M. Bigelow
[1.1.3.3.7.1.7.7.2.3]
b. 1880
William C. Lunan
b. 1876
11
Marion M Lunjan
[1.1.3.3.7.1.7.7.2.3.1]
b. Abt 1899
11
Augustus H. Lunan
[1.1.3.3.7.1.7.7.2.3.2]
b. 25 Dec 1900
8
Harriet E. Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.8]
b. 6 Feb 1821 d. 30 Nov 1904
David Franum Wood
b. 16 Feb 1818 d. 4 Feb 1896
9
Arthur Eugene Wood
[1.1.3.3.7.1.7.8.1]
b. 20 Jan 1844 d. 20 Apr 1920
Clara Hubbard Wood
b. Dec 1848
10
Alice Marion Wood
[1.1.3.3.7.1.7.8.1.1]
b. 20 Nov 1872 d. 16 Sep 1897
9
Hattie Esther Wood
[1.1.3.3.7.1.7.8.2]
b. 5 Aug 1855
Walter M Farwell
b. 1852 d. 13 Apr 1910
10
Laurence Wood Farwell
[1.1.3.3.7.1.7.8.2.1]
b. 14 Sep 1885 d. Jan 1965
+
Sarah Adelaide Adams
b. 15 Jan 1888
8
Chapin Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.9]
b. 20 Jun 1823 d. 17 Sep 1882
Julia A Smith
b. 1824 d. 21 Jun 1909
9
Luther Oscar Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.9.1]
b. 6 Oct 1848 d. 1 Nov 1904
Harriet Flora Huntress
b. 13 Nov 1850 d. 14 Mar 1935
10
Minnie Uranah Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.9.1.1]
b. 8 Aug 1872 d. 22 Sep 1872
10
Oscar Eugene Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.9.1.2]
b. 7 Jul 1876 d. 24 Jan 1912
Emma Amelia Smith
b. 11 Oct 1878 d. 29 Dec 1952
11
Eugene Charles Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.9.1.2.1]
b. 7 Mar 1904 d. 22 Sep 1981
Catherine Isabelle Orphey
b. 18 Jan 1905 d. Mar 1955
12
Charles Boyd Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.9.1.2.1.1]
b. 16 Nov 1927 d. 17 Nov 1999
11
Alice May Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.9.1.2.2]
b. 8 Dec 1906 d. 9 Jan 2000
10
Walter Ernest Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.9.1.3]
b. 16 Jan 1879 d. 1 Feb 1896
10
Alice Evaline Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.9.1.4]
b. 10 Jul 1881 d. 12 Jun 1923
Charles Edward Stearns
b. 5 Mar 1880 d. 1952
11
Harriet D. Stearns
[1.1.3.3.7.1.7.9.1.4.1]
b. 4 Jul 1903 d. 22 Feb 1982
11
Ruth L. Stearns
[1.1.3.3.7.1.7.9.1.4.2]
b. 1905 d. 1989
11
Walter Edward Stearns
[1.1.3.3.7.1.7.9.1.4.3]
b. 30 Jun 1911 d. 5 Jul 1992
+
Elizabeth W. Wells
b. 14 Oct 1909 d. 14 May 2005
11
Ralph L. Stearns
[1.1.3.3.7.1.7.9.1.4.4]
b. 20 Feb 1920 d. 14 Jun 2009
10
George Luther Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.9.1.5]
b. 21 Mar 1887
+
Ella R
b. 1892
10
Arthur Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.9.1.6]
b. 18 Jul 1889
+
Nancy A.
b. 1896
9
Loren Nelson Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.9.2]
b. 3 Jul 1850 d. 11 May 1923
Eda Annella Robinson
b. 10 Aug 1862 d. 1932
10
Morton I Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.9.2.1]
b. 12 Nov 1889 d. 20 Mar 1933
9
Eldoras Filasker Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.9.3]
b. 18 Jun 1852
Jane Maxwell
b. Dec 1852 d. 3 Nov 1935
10
Minnie Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.9.3.1]
b. 13 Aug 1875 d. 12 Feb 1946
Elmer Eugene Chase
b. Abt 1871 d. 5 Jul 1944
11
Lillian Susan Chase
[1.1.3.3.7.1.7.9.3.1.1]
b. 8 Apr 1896 d. 26 Sep 1976
+
Harold Tyson Rhodes
b. 26 Mar 1895 d. 20 Oct 1971
11
Marion Sylvia Chase
[1.1.3.3.7.1.7.9.3.1.2]
b. 21 Jan 1902 d. 17 Sep 1977
+
Orville Badger Jennison
b. 6 Aug 1896 d. May 1981
10
William Henry Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.9.3.2]
b. 29 Oct 1877
9
William Fuller Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.9.4]
b. 19 Jun 1855 d. 26 Nov 1924
Maria Sophia Giles
b. 13 Jul 1857 d. 9 Nov 1940
10
Lilla Gertrude Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.9.4.1]
b. 20 Jun 1883 d. 24 Jan 1951
Herbert Christiansen
b. 3 Jul 1877 d. 16 Nov 1941
11
Ralph William Christiansen
[1.1.3.3.7.1.7.9.4.1.1]
b. 8 Jan 1902 d. 21 Nov 1962
+
Myrtis P Barr
b. 19 Apr 1901 d. 8 Mar 1998
11
Theodore Thomas Christiansen
[1.1.3.3.7.1.7.9.4.1.2]
b. 26 Nov 1904 d. Jul 1974
11
Ida Louisa Christiansen
[1.1.3.3.7.1.7.9.4.1.3]
b. 26 Mar 1907 d. 2 Jun 1914
11
Viola Christiansen
[1.1.3.3.7.1.7.9.4.1.4]
b. 1 Dec 1909 d. 22 Apr 1995
11
Alice Shirley Christiansen
[1.1.3.3.7.1.7.9.4.1.5]
b. 23 Apr 1923 d. 12 Dec 1982
+
Frederick Irving Gray
b. 10 Dec 1913 d. 8 Apr 1997
10
Ada Emma Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.9.4.2]
b. 29 Nov 1885 d. 2 Jan 1950
William Merrick Palmer
b. 21 Apr 1860 d. 23 Dec 1949
11
Mamie Elizabeth Palmer
[1.1.3.3.7.1.7.9.4.2.1]
b. 14 Jun 1903 d. 29 Apr 1976
+
Chester Crocker Stevens
b. 17 Oct 1898 d. 19 Jan 1957
11
Gertrude Irene Palmer
[1.1.3.3.7.1.7.9.4.2.2]
b. 25 Mar 1905 d. 21 Mar 1973
+
Raymond A. Aldrich
b. 13 Nov 1901 d. 23 Mar 1949
11
Hazel Maria Palmer
[1.1.3.3.7.1.7.9.4.2.3]
b. 19 Mar 1907 d. 16 Dec 1998
+
Arthur C. Sibley
b. 2 Apr 1918 d. 25 Dec 2001
11
Bessie Louise Palmer
[1.1.3.3.7.1.7.9.4.2.4]
b. 5 Oct 1909 d. 23 Dec 1938
11
Ada Caroline Palmer
[1.1.3.3.7.1.7.9.4.2.5]
b. 18 May 1916 d. 6 Jan 2011
11
Clarence E. Palmer
[1.1.3.3.7.1.7.9.4.2.6]
b. 2 Jun 1918 d. 26 Aug 2011
11
Morene Agnes Palmer
[1.1.3.3.7.1.7.9.4.2.7]
b. 24 Jul 1920 d. 2 Jan 2010
11
Gloria Muriel Palmer
[1.1.3.3.7.1.7.9.4.2.8]
b. 19 Dec 1923 d. 24 Sep 1991
10
Cora May Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.9.4.3]
b. 7 Feb 1889 d. 1959
+
Francis E. Turner
b. 1888 d. 1975
10
Mamie Giles Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.9.4.4]
b. 6 May 1892 d. 2 Apr 1896
9
Emma E Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.9.5]
b. 30 May 1857 d. 23 Jul 1913
Albertus D Matthewson
b. 29 Nov 1850 d. 19 Mar 1911
10
Frederick E Mathewson
[1.1.3.3.7.1.7.9.5.1]
b. 23 Nov 1874
Aaron William Mason
b. 15 Aug 1847 d. 19 Mar 1904
10
William C Mason
[1.1.3.3.7.1.7.9.5.2]
b. 14 Jul 1895 d. 16 Jul 1895
8
Mary Ann Murdock
[1.1.3.3.7.1.7.10]
b. 18 Jun 1825 d. 27 Aug 1834
7
Moses Taft
[1.1.3.3.7.1.8]
b. 14 Jul 1788 d. 26 Jun 1810
7
Abigail Taft
[1.1.3.3.7.1.9]
b. 24 Jan 1791 d. 15 May 1837
Chandler Taft
b. 29 May 1792
8
Augustine Calvin Taft
[1.1.3.3.7.1.9.1]
b. 11 May 1817
Deborah Millett Taylor
9
Alice Bradford Taft
[1.1.3.3.7.1.9.1.1]
b. 26 Oct 1841
9
Edward A Taft
[1.1.3.3.7.1.9.1.2]
b. 8 Apr 1845
6
Timothy Taft
[1.1.3.3.7.2]
b. 3 Apr 1750 d. 30 Nov 1808
Priscilla Taft
b. 30 Apr 1749 d. 12 Sep 1833
7
Marcy Taft
[1.1.3.3.7.2.1]
b. 28 Sep 1771 d. 1 Aug 1848
+
Ezekiah Preston
b. Abt 1771
7
Josiah Taft
[1.1.3.3.7.2.2]
b. 3 May 1774
7
Abigail Taft
[1.1.3.3.7.2.3]
b. 14 Jan 1777 d. 17 Dec 1832
Moses Stone
b. 2 Mar 1775 d. 10 May 1803
8
Jonas Stone
[1.1.3.3.7.2.3.1]
b. 6 Jun 1795 d. 30 Sep 1795
8
Sukey Stone
[1.1.3.3.7.2.3.2]
b. 19 Feb 1798
7
Polly Taft
[1.1.3.3.7.2.4]
b. 1779 d. 5 Sep 1785
7
Timothy Taft
[1.1.3.3.7.2.5]
b. 1782 d. 5 Jan 1818
Mary "Polly" Reidel
b. 8 Feb 1784 d. 8 Feb 1863
8
Timothy Clark Taft
[1.1.3.3.7.2.5.1]
b. 21 Jul 1800 d. 11 May 1872
Mary A Hitchcock
b. 4 Jan 1802 d. 26 Oct 1842
9
Samuel Adams Taft
[1.1.3.3.7.2.5.1.1]
b. 11 Mar 1830 d. 5 Feb 1916
Jennie M Holt
b. 1841 d. 10 Feb 1882
10
Emma Julia Taft
[1.1.3.3.7.2.5.1.1.1]
b. 19 Jun 1865 d. 15 Jun 1929
Charles Almeron Westcott
b. 30 Oct 1861 d. 22 Dec 1944
11
Henry Barnard Westcott
[1.1.3.3.7.2.5.1.1.1.1]
b. 14 Nov 1885 d. 29 Oct 1950
+
Clara Ellsworth
b. 26 Aug 1887 d. 18 Jan 1973
11
Estelle Westcott
[1.1.3.3.7.2.5.1.1.1.2]
b. 30 Oct 1889 d. 6 Feb 1923
11
Harlan Westcott
[1.1.3.3.7.2.5.1.1.1.3]
b. 4 Sep 1896 d. 28 Mar 1953
11
Clayton Taft Westcott
[1.1.3.3.7.2.5.1.1.1.4]
b. 20 Mar 1900 d. 2 Mar 1939
9
Elizabeth C Taft
[1.1.3.3.7.2.5.1.2]
b. 6 Jun 1834 d. 13 Dec 1915
Franklin E Hall
b. 15 Sep 1829 d. 3 Jun 1907
10
Elizabeth C Hall
[1.1.3.3.7.2.5.1.2.1]
b. 8 Jan 1855
Edward P Thompson
b. Abt 1855
11
Lottie M Thompson
[1.1.3.3.7.2.5.1.2.1.1]
b. 18 Apr 1878
11
Son Thompson
[1.1.3.3.7.2.5.1.2.1.2]
b. 1879 d. 1879
11
Clara L Thompson
[1.1.3.3.7.2.5.1.2.1.3]
b. 27 May 1880 d. 19 Jul 1881
11
Bert J W Thompson
[1.1.3.3.7.2.5.1.2.1.4]
b. 13 Oct 1881
11
Roy Edward Thompson
[1.1.3.3.7.2.5.1.2.1.5]
b. 17 Feb 1883
11
Mabel G Thompson
[1.1.3.3.7.2.5.1.2.1.6]
b. 30 Jun 1886
+
Edward Johnson
b. Abt 1886
11
Hazel F Thompson
[1.1.3.3.7.2.5.1.2.1.7]
b. 22 Feb 1888
+
Harold Cotton
b. Abt 1888
10
Frank Erwin Hall
[1.1.3.3.7.2.5.1.2.2]
b. 6 Dec 1861 d. 26 Dec 1943
Amelia Catherine Breckenridge
b. 21 Sep 1865 d. 15 Apr 1941
11
Lelia Beatrice Hall
[1.1.3.3.7.2.5.1.2.2.1]
b. 25 Jan 1886 d. 28 Jul 1969
Ralph Edward Bachman
b. 31 Aug 1884 d. 25 Jun 1960
12
Ralph Erwin Bachman
[1.1.3.3.7.2.5.1.2.2.1.1]
b. 8 Apr 1910 d. Abt 1997
12
Virginia Catherine Bachman
[1.1.3.3.7.2.5.1.2.2.1.2]
b. 8 Apr 1910 [
=>
]
12
Richard Hall Bachman
[1.1.3.3.7.2.5.1.2.2.1.3]
b. 5 Dec 1915 d. 9 Aug 1993
12
Clyde Phillips Bachman
[1.1.3.3.7.2.5.1.2.2.1.4]
b. 14 Jul 1922
12
Gloria Bachman
[1.1.3.3.7.2.5.1.2.2.1.5]
b. 29 Nov 1927 d. 13 Dec 2007
11
Ruth Isabella Hall
[1.1.3.3.7.2.5.1.2.2.2]
b. 20 Oct 1887 d. 15 Jan 1981
+
Hans Andrew Andy Hanson
b. 10 Jul 1878 d. 7 Jul 1956
11
Aura Vella Hall
[1.1.3.3.7.2.5.1.2.2.3]
b. 26 Oct 1890 d. 24 Mar 1971
+
Albert Ursin Jorris
b. 26 Apr 1871 d. 10 Jun 1948
11
Alice May Hall
[1.1.3.3.7.2.5.1.2.2.4]
b. 15 May 1893 d. Aft 1981
Earl Freeman Grover
b. 6 Dec 1892 d. 10 Jan 1951
12
Garrison "Garry" Grover
[1.1.3.3.7.2.5.1.2.2.4.1]
b. 4 Sep 1914 d. 1 Mar 2010
12
Clark Emerson Grover
[1.1.3.3.7.2.5.1.2.2.4.2]
b. 18 Oct 1918 d. 29 Sep 2002
12
Joyce Mary Grover
[1.1.3.3.7.2.5.1.2.2.4.3]
b. 5 Apr 1921 d. 30 Oct 1998 [
=>
]
11
Donald Breckenridge Hall
[1.1.3.3.7.2.5.1.2.2.5]
b. 5 May 1900 d. 20 Aug 1900
10
Edith Mabel Hall
[1.1.3.3.7.2.5.1.2.3]
b. 13 Apr 1870 d. 2 Aug 1952
Benjamin Franklin Coffin
b. 13 Feb 1862 d. 30 Apr 1947
11
Alden Hall Coffin
[1.1.3.3.7.2.5.1.2.3.1]
b. 25 Jul 1894 d. 4 Apr 1957
+
Flo
b. Abt 1894
11
Gertrude Coffin
[1.1.3.3.7.2.5.1.2.3.2]
b. 2 Nov 1895 d. 28 Jun 1983
+
Harvey Elmer Stork
b. 28 Mar 1890 d. 30 Sep 1959
11
Eleanor Coffin
[1.1.3.3.7.2.5.1.2.3.3]
b. 11 Oct 1901 d. 28 Sep 1991
+
William Grothen
b. Abt 1901
11
Terrel Taft Coffin
[1.1.3.3.7.2.5.1.2.3.4]
b. 2 Aug 1906 d. 7 Mar 1960
+
Wallace Palmer
b. Abt 1900 d. Apr 1960
10
Gertrude Susan Hall
[1.1.3.3.7.2.5.1.2.4]
b. 26 Apr 1872 d. 6 Dec 1918
Albert Ursin Jorris
b. 26 Apr 1871 d. 10 Jun 1948
11
Edith Gertrude Jorris
[1.1.3.3.7.2.5.1.2.4.1]
b. 21 Jun 1905 d. 22 Sep 1995
+
Francois Deliscu
b. 21 Jun 1905 d. Oct 1972
11
Edwin Hall Jorris
[1.1.3.3.7.2.5.1.2.4.2]
b. 21 Jun 1905 d. 1 Apr 1992
+
Gladness Mary Oconner
b. 3 Apr 1904 d. 19 Sep 1991
8
Adolphus Taft
[1.1.3.3.7.2.5.2]
b. Abt 1804
8
Harry Taft
[1.1.3.3.7.2.5.3]
b. Abt 1806
8
Ezekiel Preston Taft
[1.1.3.3.7.2.5.4]
b. Abt 1807
8
Washington Taft
[1.1.3.3.7.2.5.5]
b. Abt 1808 d. Abt 1823
8
Charlotte Clark Taft
[1.1.3.3.7.2.5.6]
b. Abt 1810
+
Hyman Sage
b. Abt 1810
8
Christine Taft
[1.1.3.3.7.2.5.7]
b. 1811 d. 8 Jul 1847
+
George Heath
b. Abt 1811
8
Jacob R Taft
[1.1.3.3.7.2.5.8]
b. 29 Oct 1814 d. 1 Jan 1875
+
Caroline Cowles
b. 10 Jun 1817 d. 25 Jun 1875
7
Joseph Taft
[1.1.3.3.7.2.6]
b. 1784
7
Jonas Taft
[1.1.3.3.7.2.7]
b. 1786
7
Polly Taft
[1.1.3.3.7.2.8]
b. 1788 d. 1859
6
Jacob Taft
[1.1.3.3.7.3]
b. 1 Dec 1751 d. 30 May 1823
Mary Taft
b. 14 Feb 1753 d. 19 Jul 1832
7
Lois Taft
[1.1.3.3.7.3.1]
b. 27 Aug 1780 d. 27 Apr 1854
Josiah Seagrave
b. 14 Oct 1773 d. 20 Mar 1855
8
Mary Ann Seagrave
[1.1.3.3.7.3.1.1]
b. 17 Nov 1799 d. 10 Feb 1825
8
Jacob Taft Seagraves
[1.1.3.3.7.3.1.2]
b. 8 Apr 1802 d. 24 Sep 1870
8
Henrietta Frost Seagrave
[1.1.3.3.7.3.1.3]
b. 1 Dec 1803 d. 1 Jun 1823
8
Waity Grant Seagrave
[1.1.3.3.7.3.1.4]
b. 23 Sep 1805 d. 27 Jan 1859
8
Edward Seagrave
[1.1.3.3.7.3.1.5]
b. 3 Sep 1807 d. 15 Feb 1873
8
Lois Taft Seagrave
[1.1.3.3.7.3.1.6]
b. 13 Apr 1809 d. 19 Mar 1853
8
Josiah Seagrave, Jr
[1.1.3.3.7.3.1.7]
b. 24 May 1811 d. 21 Jul 1861
8
Malvina Seagrave
[1.1.3.3.7.3.1.8]
b. 2 Apr 1813 d. 16 Dec 1823
8
Caleb Seagrave
[1.1.3.3.7.3.1.9]
b. 8 Feb 1815 d. 14 Nov 1823
8
Son Seagrave
[1.1.3.3.7.3.1.10]
b. 3 May 1817 d. 3 May 1817
8
Daughter Seagrave
[1.1.3.3.7.3.1.11]
b. 3 May 1817 d. 3 May 1817
8
Esborn Seagrave
[1.1.3.3.7.3.1.12]
b. 28 Dec 1818 d. 27 Oct 1856
8
George Augustus Seagrave
[1.1.3.3.7.3.1.13]
b. 6 Jan 1823 d. 15 Nov 1884
7
Hannah Margaret Taft
[1.1.3.3.7.3.2]
b. 28 Nov 1782 d. 2 Apr 1857
Stephen Carpenter
b. 13 Aug 1778 d. 1 Oct 1854
8
Eunice Carpenter
[1.1.3.3.7.3.2.1]
b. Sep 1802 d. Mar 1864
8
Orsmus T Carpenter
[1.1.3.3.7.3.2.2]
b. Jan 1805 d. 4 Apr 1863
8
Joseph Rawson Carpenter
[1.1.3.3.7.3.2.3]
b. 2 Apr 1807 d. May 1839
8
Charlotte Taft Carpenter
[1.1.3.3.7.3.2.4]
b. 4 Feb 1809 d. 5 Sep 1845
8
Charles A Carpenter
[1.1.3.3.7.3.2.5]
b. 11 Feb 1813 d. 12 Aug 1887
8
Mary T Carpenter
[1.1.3.3.7.3.2.6]
b. 1815
8
Hannah Taft Carpenter
[1.1.3.3.7.3.2.7]
b. 20 Aug 1817 d. 17 Dec 1890
8
Nancy Carter Carpenter
[1.1.3.3.7.3.2.8]
b. 5 Jun 1820 d. 15 May 1898
8
Henrietta Carpenter
[1.1.3.3.7.3.2.9]
b. Apr 1823 d. Feb 1847
8
George Carpenter
[1.1.3.3.7.3.2.10]
b. 13 Jan 1825
7
Elisabeth Taft
[1.1.3.3.7.3.3]
b. 8 Nov 1784
Ephraim Taft
b. 18 Aug 1780
8
Mary Ann Taft
[1.1.3.3.7.3.3.1]
b. 22 May 1805
8
Ephriam Taft
[1.1.3.3.7.3.3.2]
b. 8 Feb 1807
7
Mary Taft
[1.1.3.3.7.3.4]
b. 16 Mar 1786 d. 25 Feb 1860
7
Charlotte Taft
[1.1.3.3.7.3.5]
b. 25 Feb 1789
7
John Taft
[1.1.3.3.7.3.6]
b. 3 Dec 1792 d. 29 May 1826
Lucretia Newell
b. 24 Sep 1795 d. 29 Dec 1863
8
Robert Taft
[1.1.3.3.7.3.6.1]
b. 27 May 1819
8
Jacob Taft
[1.1.3.3.7.3.6.2]
b. 19 May 1823
7
Orsmus Taft
[1.1.3.3.7.3.7]
b. 1 Jan 1795
6
Abigail Taft
[1.1.3.3.7.4]
b. 5 Oct 1754 d. 12 Aug 1775
Barzillai Taft
b. 3 Nov 1750 d. 21 Jan 1839
7
Eunice Taft
[1.1.3.3.7.4.1]
b. 28 Jan 1775 d. 30 May 1861
Phineas Chapin
b. 3 Aug 1769 d. 3 May 1839
8
Abby Chapin
[1.1.3.3.7.4.1.1]
b. 1 Feb 1796
8
Laurinda Chapin
[1.1.3.3.7.4.1.2]
b. 6 Feb 1798 d. 20 Dec 1866
8
Sarah Richardson Chapin
[1.1.3.3.7.4.1.3]
b. 30 Apr 1800 d. 16 Apr 1884
8
Chloe T Chapin
[1.1.3.3.7.4.1.4]
b. 8 Apr 1802 d. 5 Oct 1881
8
Mary Warren Chapin
[1.1.3.3.7.4.1.5]
b. 27 Feb 1804 d. 13 Nov 1890
8
Caleb Chapin
[1.1.3.3.7.4.1.6]
b. 6 Feb 1806 d. 27 Sep 1883
Clarissa Wood Taft
b. 3 May 1810 d. 1889
9
Eunice Chapin
[1.1.3.3.7.4.1.6.1]
b. 1 May 1832 d. 29 Sep 1920
Samuel Mills Capron
b. 15 May 1832 d. 4 Jan 1874
10
Helen Maria Capron
[1.1.3.3.7.4.1.6.1.1]
b. 26 Mar 1858 d. 6 Jan 1863
10
Alice Louise Capron
[1.1.3.3.7.4.1.6.1.2]
b. 26 Mar 1862 d. 13 Jan 1863
10
Clara D Capron
[1.1.3.3.7.4.1.6.1.3]
b. 4 Aug 1864
10
Bertha C Capron
[1.1.3.3.7.4.1.6.1.4]
b. 16 Mar 1868
Samuel Bostwick Robbins
b. 15 Oct 1867 d. 1948
11
Samuel Capron Robbins
[1.1.3.3.7.4.1.6.1.4.1]
b. 21 May 1902
10
William Cargill Capron
[1.1.3.3.7.4.1.6.1.5]
b. 27 Jul 1869
Adalaide Griswold
b. Abt 1873
11
Robert Griswold Capron
[1.1.3.3.7.4.1.6.1.5.1]
b. 20 Nov 1895
9
Ezra Wood Chapin
[1.1.3.3.7.4.1.6.2]
b. 7 Jun 1836 d. 31 Mar 1909
Ellen Frances Cooper
b. 30 Dec 1835
10
Janet Chapin
[1.1.3.3.7.4.1.6.2.1]
b. 28 May 1870
9
Edwin Chapin
[1.1.3.3.7.4.1.6.3]
b. 7 Jun 1836 d. 27 Sep 1836
8
Margaret Ann Chapin
[1.1.3.3.7.4.1.7]
b. 16 Jun 1808 d. 15 Nov 1897
8
Bezaileel Taft Chapin
[1.1.3.3.7.4.1.8]
b. 21 Oct 1810 d. 28 May 1855
8
Samuel Judson Chapin
[1.1.3.3.7.4.1.9]
b. 27 Aug 1812 d. 18 Nov 1908
8
Son Chapin
[1.1.3.3.7.4.1.10]
b. 15 Oct 1815
8
Gardner Spring Chapin
[1.1.3.3.7.4.1.11]
b. 2 Oct 1817 d. 4 Aug 1892
8
Josiah Spring Chapin
[1.1.3.3.7.4.1.12]
b. 24 Aug 1820 d. 26 Dec 1882
6
Lois Taft
[1.1.3.3.7.5]
b. 28 Apr 1757 d. 10 Feb 1792
Caleb Farnum
b. 9 Nov 1753 d. 3 Jan 1829
7
Royal Farnham
[1.1.3.3.7.5.1]
b. 28 Nov 1775 d. 3 Sep 1845
+
Betsey Whitney
b. 29 Jul 1779
7
Easman Farnum
[1.1.3.3.7.5.2]
b. 22 Dec 1777
Rebecca Chamberlain
b. 10 Feb 1778
8
Almira Farnum
[1.1.3.3.7.5.2.1]
b. 1801 d. 24 Jan 1829
8
George V R Farnham
[1.1.3.3.7.5.2.2]
b. 12 Sep 1812 d. 3 Jul 1871
Nancy
b. 1815
9
Oscar W Farnham
[1.1.3.3.7.5.2.2.1]
b. 12 Nov 1835
7
Caleb Farnum
[1.1.3.3.7.5.3]
b. 15 Jul 1781 d. 16 Jun 1863
Silvania Allen
b. 5 Mar 1782 d. 13 Oct 1846
8
Elizabeth F Farnham
[1.1.3.3.7.5.3.1]
b. 21 Apr 1805 d. 20 Jul 1827
Mellen Garner Kempton
b. 20 Feb 1805 d. 4 Feb 1893
9
George Mellen Kempton
[1.1.3.3.7.5.3.1.1]
b. 13 Jun 1827 d. 29 Mar 1911
8
George A Farnham
[1.1.3.3.7.5.3.2]
b. 27 Jun 1807
+
Angeline Hanks
b. 1808 d. 1 Jan 1877
+
Sarah Taylor
b. Abt 1814
8
Clarissa Taft Farnum
[1.1.3.3.7.5.3.3]
b. 27 Jun 1807 d. 26 Oct 1839
+
Dugald Cameron Taylor
8
Edward Judson Farnham
[1.1.3.3.7.5.3.4]
b. 16 Mar 1809 d. 11 Jul 1894
Lucy G Goff
b. Abt 1809 d. 12 Oct 1876
9
Frances Farnham
[1.1.3.3.7.5.3.4.1]
b. 1830 d. 1857
9
Antoinette Farnham
[1.1.3.3.7.5.3.4.2]
b. Abt 1833
+
Edwin B Hall
b. Abt 1832
9
Louise Adelaide Farnum
[1.1.3.3.7.5.3.4.3]
b. Abt 1835
+
Alfred Stewart Brown
b. Abt 1834
9
Sylvania Allen Farnham
[1.1.3.3.7.5.3.4.4]
b. 1836
9
Fanny Louisa Farnham
[1.1.3.3.7.5.3.4.5]
b. 1838
+
J Milton Carpenter
b. 1835
9
William Carlton Farnham
[1.1.3.3.7.5.3.4.6]
b. 1840
8
Caroline Farnum
[1.1.3.3.7.5.3.5]
b. 13 Aug 1810 d. 26 Aug 1810
8
Carleton Lee Farnham
[1.1.3.3.7.5.3.6]
b. 13 Jul 1811
Sarah Gaylord
b. Abt 1818 d. 23 Jul 1892
9
Edward G Farnum
[1.1.3.3.7.5.3.6.1]
b. 27 Jan 1840
9
Charles Caleb Farnum
[1.1.3.3.7.5.3.6.2]
b. 11 Sep 1841
9
Emily Adelaide Farnum
[1.1.3.3.7.5.3.6.3]
b. 21 Oct 1843 d. 24 Apr 1883
+
Sanford Jenkins
b. 1839 d. 1873
9
William Haddard Farnum
[1.1.3.3.7.5.3.6.4]
b. 27 Jan 1845 d. 22 Jan 1850
9
George Eugene Farnum
[1.1.3.3.7.5.3.6.5]
b. 9 Nov 1845
Mary Alice Richmond
b. 1845
10
Inez G. Farnum
[1.1.3.3.7.5.3.6.5.1]
b. 28 Dec 1887
+
Elmer D Spicer
b. 1885
10
Gaylord Richard Farnum
[1.1.3.3.7.5.3.6.5.2]
b. 17 Jan 1891
9
William Stoddard Farnum
[1.1.3.3.7.5.3.6.6]
b. 27 Jan 1848 d. 22 Jan 1856
9
Clarence Asher Farnum
[1.1.3.3.7.5.3.6.7]
b. 7 Oct 1850
+
Corinne A Hanks
b. Abt 1852
9
Mary Gaylord Farnum
[1.1.3.3.7.5.3.6.8]
b. 14 Jan 1854
+
Chauncey B Macken
b. 1854
8
William A Farnham
[1.1.3.3.7.5.3.7]
b. 13 Mar 1813 d. 28 Feb 1814
8
William A Farnham
[1.1.3.3.7.5.3.8]
b. 13 Aug 1815 d. 2 Aug 1860
+
Pheobe Adams
b. 1821
8
Dorcas Adelaide Farnum
[1.1.3.3.7.5.3.9]
b. 9 Jun 1820 d. 13 Aug 1842
8
Mary Frances Farnham
[1.1.3.3.7.5.3.10]
b. 29 Jul 1823 d. 1 Jan 1847
+
William Stoddard
+
Sally Jones
b. 1783 d. 12 May 1874
7
Clarissa Farnam
[1.1.3.3.7.5.4]
b. 22 Aug 1784
+
Elihu Morgan
b. 1780
6
Mercy Taft
[1.1.3.3.7.6]
b. 5 Mar 1758 d. 18 Feb 1843
Otis Russell
b. 9 Dec 1733
7
Meribah Russell
[1.1.3.3.7.6.1]
b. 1805 d. Aft 1860
6
Israel Taft
[1.1.3.3.7.7]
b. 1 Mar 1761 d. 24 Apr 1842
Submit Read
b. 21 Jun 1763 d. 17 May 1841
7
Ruth Taft
[1.1.3.3.7.7.1]
b. 5 Jan 1783
Benjamin Farrow
b. 9 Mar 1782 d. 17 Oct 1861
8
Drucilla Farrow
[1.1.3.3.7.7.1.1]
b. 10 Apr 1805 d. 7 Nov 1896
8
Theodore Grey Farrow
[1.1.3.3.7.7.1.2]
b. 25 Feb 1807 d. 23 Jan 1907
8
Submit Farrow
[1.1.3.3.7.7.1.3]
b. 4 Jan 1809 d. 22 Nov 1882
8
Cecelia Farrow
[1.1.3.3.7.7.1.4]
b. 26 May 1810 d. 18 Jul 1835
8
Israel Taft Farrow
[1.1.3.3.7.7.1.5]
b. 25 May 1812 d. 23 Apr 1903
8
Franklin Farrow
[1.1.3.3.7.7.1.6]
b. 31 Aug 1813 d. 3 Feb 1892
8
Independence Farrow
[1.1.3.3.7.7.1.7]
b. 4 Jul 1815 d. 7 Sep 1891
8
Constantine Farrow
[1.1.3.3.7.7.1.8]
b. 11 Mar 1817 d. 28 Feb 1871
8
Lucy Farrow
[1.1.3.3.7.7.1.9]
b. 13 Oct 1819 d. 12 Jul 1850
8
Benjamin Farrow
[1.1.3.3.7.7.1.10]
b. 13 Oct 1819 d. 17 Oct 1819
8
Caleb Walter Farrow
[1.1.3.3.7.7.1.11]
b. 16 Jan 1823 d. 26 Jul 1860
8
Emeline Farrow
[1.1.3.3.7.7.1.12]
b. 16 Jun 1824 d. 30 Aug 1842
8
Miranda Farrow
[1.1.3.3.7.7.1.13]
b. 5 Jul 1827 d. 2 Feb 1877
7
Clarisa Taft
[1.1.3.3.7.7.2]
b. 5 Mar 1786
7
Elzaphan Taft
[1.1.3.3.7.7.3]
b. 15 Feb 1788 d. 23 Mar 1847
Elisabeth Fowler
b. 1791 d. 30 Sep 1871
8
Gilbert Chase Taft
[1.1.3.3.7.7.3.1]
b. 22 Nov 1813
8
Emila Angenett Taft
[1.1.3.3.7.7.3.2]
b. 15 Sep 1815
8
Samuel Read Taft
[1.1.3.3.7.7.3.3]
b. 6 Aug 1818 d. 30 Aug 1835
8
John E Taft
[1.1.3.3.7.7.3.4]
b. 25 Feb 1821
8
Cyrus Taft
[1.1.3.3.7.7.3.5]
b. 27 Nov 1824 d. 6 Feb 1832
8
Lucinda M Taft
[1.1.3.3.7.7.3.6]
b. 26 Jul 1827
8
Elizabeth G. Taft
[1.1.3.3.7.7.3.7]
b. 17 May 1833
7
Abigail Taft
[1.1.3.3.7.7.4]
b. 9 Feb 1790 d. 5 Jun 1791
7
Laurana Taft
[1.1.3.3.7.7.5]
b. 13 May 1792
Cheany Taft
b. 8 Dec 1787 d. 13 Feb 1840
8
Caleb Walter Taft
[1.1.3.3.7.7.5.1]
b. 11 Oct 1813 d. 19 Dec 1813
8
Henry Cheney Taft
[1.1.3.3.7.7.5.2]
b. 20 Apr 1815
7
Lydia Mariah Taft
[1.1.3.3.7.7.6]
b. 10 Jul 1794
Washington White
b. 17 May 1796
8
Ruth Taft White
[1.1.3.3.7.7.6.1]
b. 16 Jun 1819
8
Sarah Ann White
[1.1.3.3.7.7.6.2]
b. 17 Sep 1821
8
Lurana Taft White
[1.1.3.3.7.7.6.3]
b. 14 Apr 1823
8
Lydia Mariah White
[1.1.3.3.7.7.6.4]
b. 3 Apr 1825
8
Eunice Fletcher White
[1.1.3.3.7.7.6.5]
b. 1 Jan 1827
8
Mary Elizabeth White
[1.1.3.3.7.7.6.6]
b. 15 Sep 1829
8
Margaret B White
[1.1.3.3.7.7.6.7]
b. 20 Jul 1833
8
Caroline Frances White
[1.1.3.3.7.7.6.8]
b. 20 Jan 1835
8
Henry Kirk White
[1.1.3.3.7.7.6.9]
b. 10 May 1837
8
William Edwards White
[1.1.3.3.7.7.6.10]
b. 8 Mar 1839
8
Lucy B White
[1.1.3.3.7.7.6.11]
b. 16 Oct 1841
8
Emma Jane White
[1.1.3.3.7.7.6.12]
b. 18 Feb 1845
7
Cyrus Taft
[1.1.3.3.7.7.7]
b. 3 Feb 1797
Lucinda Morse
b. 1800 d. 25 Jul 1860
8
Gustavus Elzaphan Taft
[1.1.3.3.7.7.7.1]
b. 29 Aug 1829 d. 23 Jun 1888
8
Son Taft
[1.1.3.3.7.7.7.2]
b. 1831
8
Peter Morse Taft
[1.1.3.3.7.7.7.3]
b. 1833
8
Edmond M Taft
[1.1.3.3.7.7.7.4]
b. 1834 d. 25 Oct 1858
7
Louis Taft
[1.1.3.3.7.7.8]
b. 25 Apr 1801
6
Eastman Taft
[1.1.3.3.7.8]
b. 16 Jun 1763 d. 29 Apr 1829
Chloa Taft
b. 25 Nov 1763 d. 4 May 1783
7
Eastman Taft
[1.1.3.3.7.8.1]
b. 2 May 1783 d. 8 Aug 1857
Hannah Taft
b. 1 Nov 1763 d. 3 Jul 1832
7
Chloe Taft
[1.1.3.3.7.8.2]
b. 7 Jul 1785 d. 25 Apr 1826
John Perry Benson
b. 22 Jul 1781 d. 21 Jan 1842
8
Charlotte Taft Benson
[1.1.3.3.7.8.2.1]
b. 30 Sep 1807 d. 16 Jul 1878
Moses Dyer
b. 1803 d. Aft 1841
9
Merril B Dyer
[1.1.3.3.7.8.2.1.1]
b. 2 Apr 1844 d. 2 Apr 1859
9
George Franklin Dyer
[1.1.3.3.7.8.2.1.2]
b. 22 Jan 1846 d. 27 Feb 1917
Ellen Jane Hubbard
b. 1848 d. 1925
10
Merrill Eugene Dyer
[1.1.3.3.7.8.2.1.2.1]
b. 18 Dec 1869 d. 1926
Lena Hartshorn
b. 1872
11
Hazel Dyer
[1.1.3.3.7.8.2.1.2.1.1]
b. 5 Sep 1899 d. 24 Oct 1984
11
Leo Carlton Dyer
[1.1.3.3.7.8.2.1.2.1.2]
b. 22 Jan 1902 d. 18 Jul 1910
11
Clara Dyer
[1.1.3.3.7.8.2.1.2.1.3]
b. 15 Dec 1902 d. 24 Jul 1998
9
Chloe Allice Dyer
[1.1.3.3.7.8.2.1.3]
b. 5 May 1848 d. 1932
Sanford Brown
b. 10 Feb 1844 d. 1883
10
Charlotta B Brown
[1.1.3.3.7.8.2.1.3.1]
b. 22 Feb 1871
+
Clements Roehrig
b. 1869
10
Paul Brown
[1.1.3.3.7.8.2.1.3.2]
b. 12 Jan 1873 d. 24 Nov 1952
Beatrice Hart
b. 1872
11
Ruth Brown
[1.1.3.3.7.8.2.1.3.2.1]
b. 18 Aug 1899
+
Harold E Sweeney
b. 1 Dec 1899
10
Sanford Brown
[1.1.3.3.7.8.2.1.3.3]
b. 17 Mar 1876 d. 5 Sep 1905
+
Clara Marie Perry
b. Dec 1875
10
Elizabeth Brown
[1.1.3.3.7.8.2.1.3.4]
b. 25 May 1879
+
Alfred E Truman
b. 1877
10
Neil Brown
[1.1.3.3.7.8.2.1.3.5]
b. 25 Mar 1882 d. 5 Nov 1913
9
Angelne A Dyer
[1.1.3.3.7.8.2.1.4]
b. 6 Sep 1852
Orison J Batchelor
b. 11 Jul 1851 d. 10 Jan 1913
10
Chloe Edith Bachelor
[1.1.3.3.7.8.2.1.4.1]
b. 11 Sep 1873
10
Nina F Bachelor
[1.1.3.3.7.8.2.1.4.2]
b. 30 Nov 1875
10
Maria Frances Bachelor
[1.1.3.3.7.8.2.1.4.3]
b. 30 Nov 1875
8
Ezra Taft Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2]
b. 22 Feb 1811 d. 3 Sep 1869
Pamelia Andrus
b. 21 Oct 1809 d. 14 Sep 1877
9
Charles Agustus Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.1]
b. 26 Sep 1832 d. 14 Oct 1833
9
Chloe Jane Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.2]
b. 1835 d. 1835
9
Charles Augustus Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.3]
b. 9 Jul 1837 d. 18 Feb 1873
9
Jonathan Parsons Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.4]
b. Mar 1841 d. Mar 1841
9
Adin Parsons Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.5]
b. Mar 1841 d. Mar 1841
9
Pamelia Emma Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.6]
b. 28 Feb 1842 d. 10 Feb 1892
9
Harvey Andrus Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.7]
b. 26 Sep 1844 d. 26 Sep 1844
9
Isabella Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.8]
b. 9 Mar 1846 d. 10 Feb 1922
9
Charlotte Taft Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.9]
b. 4 Jul 1850 d. 30 Nov 1918
Winfield Scott Norcross
b. 16 Jul 1844 d. 7 Jan 1915
10
Irving Norcross
[1.1.3.3.7.8.2.2.9.1]
b. 1880
10
Winfield Irvin Norcross
[1.1.3.3.7.8.2.2.9.2]
b. 18 Jun 1884
Adeline Brooks Andrus
b. 18 Mar 1813 d. 20 Apr 1898
9
George Taft Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10]
b. 1 May 1846 d. 16 May 1919
Louisa Alexandrine Ballif
b. 25 Feb 1850 d. 7 Feb 1922
10
Louisa "Lulu" Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.1]
b. 28 Mar 1869 d. 15 Jul 1938
William Chandler Parkinson
b. 2 Aug 1855 d. 18 Nov 1929
11
Louisa Benson Parkinson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.1.1]
b. 5 Jul 1889 d. 12 Sep 1973
Curtis Young Clawson
b. 27 Jul 1884 d. 5 Aug 1941
12
Nabbie Louise Clawson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.1.1.1]
b. 5 Apr 1912 d. 16 Jan 1992 [
=>
]
12
Jeannette Clawson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.1.1.2]
b. 16 Apr 1914 d. 26 Nov 1983 [
=>
]
12
William Curtis Clawson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.1.1.3]
b. 12 Dec 1919 d. 22 Oct 1997
11
Marie Benson Parkinson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.1.2]
b. 13 Dec 1891 d. 22 Jan 1919
11
Charlotte Benson Parkinson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.1.3]
b. 16 Jul 1894 d. 13 Oct 1980
11
Clara Parkinson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.1.4]
b. 8 Aug 1897 d. 6 Oct 1992
Franklin Ross Anderson
b. 28 Jun 1897 d. 22 Jul 1957
12
Clara Jean Anderson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.1.4.1]
b. 3 Feb 1919 d. 17 Sep 1994
12
Kathryn Anderson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.1.4.2]
b. 3 Mar 1922 d. 13 Mar 2000
11
George Benson Parkinson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.1.5]
b. 17 Oct 1899 d. 31 Oct 1918
11
Adeline Parkinson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.1.6]
b. 2 Jan 1902 d. 27 Apr 1990
George Lloyd Wyman
b. 16 Sep 1895 d. 4 Dec 1969
12
Patricia Ann Wyman
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.1.6.1]
b. 13 Nov 1940 d. 17 Apr 2000
11
Wilbur Chandler Parkinson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.1.7]
b. 10 Oct 1904 d. 20 Dec 1988
Darlene Gladys Stevenson
b. 12 Jan 1902 d. 20 Mar 1986
12
Living
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.1.7.1]
12
Living
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.1.7.2]
11
Carmen Parkinson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.1.8]
b. 5 Oct 1907 d. 24 Mar 1993
Charles Jacob Brock
b. 28 Jan 1907 d. 13 Jun 1966
12
Janice Brock
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.1.8.1]
b. 12 Dec 1929 d. 20 Jul 2009
12
Joanne Brock
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.1.8.2]
b. 12 Dec 1929 d. 26 Aug 2011 [
=>
]
12
Charles Richard Brock
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.1.8.3]
b. 26 Jun 1931 d. 23 Aug 1941
12
Patricia Brock
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.1.8.4]
b. 18 Oct 1937 d. 11 Mar 2015
11
Evelyn Parkinson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.1.9]
b. 30 Mar 1910 d. 30 Jun 1991
+
Max Porter Brown
b. 9 Jan 1908 d. 11 Aug 1991
11
Wanda Parkinson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.1.10]
b. 31 Jul 1911 d. 13 Jun 1995
Winfield Quayle Cannon
b. 31 Aug 1908 d. 2 Mar 1998
12
Stuart Quayle Cannon
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.1.10.1]
b. 20 Mar 1933 d. 21 Feb 2014
10
Ezra Taft Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.2]
b. 6 Aug 1871 d. 28 Aug 1871
10
Elise Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.3]
b. 10 Mar 1873 d. 22 Aug 1937
George Alfred Alder, Jr
b. 4 Jan 1874 d. 3 May 1940
11
Ione Benson Alder
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.3.1]
b. 9 Jul 1896 d. 6 Oct 1983
Quincy Burt Coray
b. 28 Oct 1895 d. 18 Oct 1985
12
Daughter Coray
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.3.1.1]
b. 11 Jan 1929 d. 11 Jan 1929
11
Lydia Dunford Alder
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.3.2]
b. 30 Nov 1898 d. 7 Aug 1983
+
Leroy Harrison Bean
b. 26 Aug 1889 d. 8 Mar 1957
11
Linden Benson Alder
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.3.3]
b. 20 Mar 1900 d. 8 Aug 1957
Georgia Ellen Payzant
b. 22 Feb 1905 d. 31 Aug 1992
12
Richard Jerome Alder
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.3.3.1]
b. 12 May 1931 d. 12 May 1931
12
Daniel Blaine Alder
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.3.3.2]
b. 25 May 1936 d. 28 May 1936
11
Garold Benson Alder
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.3.4]
b. 2 May 1902 d. 12 Jun 1960
Norma Blake
b. 29 Aug 1904 d. 1 May 1997
12
Lawrence Wesley Alder
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.3.4.1]
b. 28 Dec 1933 d. 9 Jun 2014
11
George Benson Alder
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.3.5]
b. 1 May 1906 d. 11 Nov 1974
Florence Egan
b. 28 Feb 1911 d. 28 Sep 1981
12
David Egan Alder
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.3.5.1]
b. 21 Jan 1935 d. 3 Aug 2014
12
Living
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.3.5.2]
12
Diane Elise Alder
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.3.5.3]
b. 12 Feb 1940 d. 4 Jun 2005
12
Kent Egan Alder
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.3.5.4]
b. 21 Sep 1941 d. 29 Jun 2004
11
Ballif Benson Alder
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.3.6]
b. 1 May 1906 d. 23 Nov 1906
11
Donald Benson Alder
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.3.7]
b. 4 Dec 1908 d. 14 Mar 1993
Elsie Marie Loveland
b. 22 Feb 1914 d. 11 Nov 2003
12
Gordon Jerome Alder
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.3.7.1]
b. 1 Feb 1935 d. 20 Jun 1936
11
George Alfred Alder
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.3.8]
b. 9 Jul 1912 d. 29 Mar 1913
10
George Taft Benson, Jr
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4]
b. 24 Jun 1875 d. 13 Aug 1934
Sarah Sophia Dunkley
b. 29 Jun 1878 d. 1 Jun 1933
11
Ezra Taft Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.1]
b. 4 Aug 1899 d. 30 May 1994
Flora Smith Amussen
b. 1 Jul 1901 d. 14 Aug 1992
12
Reed Amussen Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.1.1]
b. 2 Jan 1928 d. 24 Aug 2016 [
=>
]
12
Mark Amussen Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.1.2]
b. 2 May 1929 d. 29 Jul 2012 [
=>
]
12
Barbara Amussen Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.1.3]
b. 20 Jun 1934 d. 26 Mar 2020 [
=>
]
12
Beverly Amussen Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.1.4]
12
Bonnie Amussen Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.1.5]
12
Flora Beth Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.1.6]
11
Joseph Dunkley Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.2]
b. 12 Nov 1900 d. 24 Apr 1936
Iva Laura Jones
b. 16 Jun 1905 d. 10 Dec 1978
12
Joe Dell Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.2.1]
b. 18 Jan 1931 d. 13 Sep 1978
12
Colleen Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.2.2]
b. 12 Mar 1929 d. 27 Oct 2006
12
David Keith Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.2.3]
b. 12 Aug 1936 d. 21 Sep 2020
11
Margaret Dunkley Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.3]
b. 16 Feb 1902 d. 3 Jul 1999
Rulon Morgan Keller
b. 21 Jan 1901 d. 13 Jan 1970
12
Rulon Benson Keller
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.3.1]
b. 13 Dec 1923 d. 16 Feb 1924
12
Benson James Keller
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.3.2]
b. 29 Jun 1925 d. 7 Feb 1926
12
Mar Rue Keller
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.3.3]
b. 10 Mar 1928 d. 28 Dec 2021
12
Marco Keller
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.3.4]
b. 26 Sep 1929 d. 2 Nov 2008
12
Sara Beth Keller
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.3.5]
b. 13 Jan 1932 d. 10 May 2009
12
Lamond Benson Keller
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.3.6]
b. 11 May 1934 d. 31 May 2012
12
Living
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.3.7]
12
Living
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.3.8]
11
Orval Dunkley Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.4]
b. 30 Aug 1903 d. 1 Jul 1991
Lourena May Clayson
b. 7 May 1907 d. 4 May 1997
12
Orval Clayson Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.4.1]
b. 8 Feb 1933 d. 5 Apr 2021
12
Kent Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.4.2]
b. 2 Dec 1934 d. 4 Jul 1995 [
=>
]
12
Mignon Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.4.3]
b. 20 Oct 1936 d. 25 Dec 1936
12
Morris Clayson Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.4.4]
b. 21 Dec 1939 d. 6 Oct 2013 [
=>
]
12
Larry Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.4.5]
12
Marsha Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.4.6]
12
Vaughn Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.4.7]
11
Louisa Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.5]
b. 10 Oct 1905 d. 2 Jul 1996
Quentin Edward Greenwood
b. 8 Apr 1907 d. 6 Feb 1999
12
Donald Greenwood
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.5.1]
12
Janet Greenwood
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.5.2]
b. 11 Apr 1934 d. 2018
12
David Greenwood
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.5.3]
12
Evelyn Greenwood
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.5.4]
11
Lera Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.6]
b. 4 May 1907 d. 10 Jun 2009
Cyril Monroe Whittle
b. 26 Sep 1902 d. 15 Apr 1961
12
Sabra Whittle
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.6.1]
b. 19 Jan 1933 d. 1 Feb 2002 [
=>
]
12
William Monroe Whittle
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.6.2]
b. 22 Jun 1935 d. 5 Feb 2016
12
George Benson Whittle
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.6.3]
b. 27 Mar 1944 d. 27 Jul 2011
12
Valerie Whittle
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.6.4]
b. 16 Nov 1947 d. 3 Feb 2010 [
=>
]
12
Lee Monroe Whittle
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.6.5]
b. Abt 1949 d. 25 Dec 2017
11
Valdo Dunkley Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.7]
b. 23 Apr 1911 d. 30 Oct 1990
Ruth Watkins
b. 12 Oct 1916 d. 7 Feb 2006
12
Lauralie Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.7.1]
12
John Taft Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.7.2]
b. 4 Jan 1944 d. 14 Nov 2019
12
Ralph V Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.7.3]
12
Rebecca Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.7.4]
12
JoAnn Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.7.5]
11
George Taft Benson, III
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.8]
b. 27 Aug 1912 d. 15 Apr 1990
Wilma Maudell "Billie" Harris
b. 25 Nov 1917 d. 16 Nov 1968
12
Mardi Gail Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.8.1]
b. 14 Jun 1941 d. 27 Apr 2015
12
George Taft Benson, IV
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.8.2]
b. 9 Dec 1943 d. 13 Jul 2010
12
Maureen M Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.8.3]
12
Linda W Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.8.4]
12
Jacquelyn Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.8.5]
12
Janet W Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.8.6]
12
Susan W Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.8.7]
12
Brian Harris Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.8.8]
+
Venice Pugmire
b. 25 Aug 1916 d. 4 Mar 1971
+
Jane Seare
b. 25 Mar 1917 d. 17 Apr 2011
11
Sarah Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.9]
b. 30 Sep 1914 d. 26 Sep 2001
Achton Christian Jensen
b. 24 Dec 1904 d. 21 Aug 1978
12
Jerry Wayne Jensen
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.9.1]
b. 19 Mar 1938 d. 6 Aug 2012
+
Thomas Eben Eveleth
b. 20 Jan 1914 d. 15 Nov 2003
11
Ross Dean Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.10]
b. 20 Jan 1917 d. 23 Oct 1985
+
Barbara Jean White
b. 11 Jul 1920 d. 25 Feb 2004
11
Volco Ballif Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.4.11]
b. 11 Apr 1920 d. 13 Mar 1992
+
Helen Anderson
b. 21 Apr 1919 d. 4 Feb 1999
+
Clara Maria Danielsen
b. 10 Feb 1892 d. 20 Oct 1958
10
Serge Ballif Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.5]
b. 2 Oct 1877 d. 18 Jan 1959
Melinda Caroline Nelson
b. 8 Sep 1881 d. 27 Jun 1971
11
Sergene Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.5.1]
b. 7 Aug 1904 d. 23 Jun 1995
Frank Charles Simmons
b. 23 Jan 1904 d. 1 Apr 1990
12
Linda Lou Simmons
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.5.1.1]
b. 12 Apr 1937 d. 24 May 1948
12
Serge Benson Simmons
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.5.1.2]
b. 4 Mar 1944 d. 2 Nov 1969 [
=>
]
11
Serge Nelson Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.5.2]
b. 15 Mar 1906 d. 28 Oct 1994
Elizabeth Ruth Horton
b. 1 Oct 1906 d. 15 May 1994
12
Sergene Elizabeth Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.5.2.1]
b. 5 Apr 1932 d. 16 Oct 2014
12
Donna Louise Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.5.2.2]
b. 17 Apr 1938 d. 9 Dec 2011
11
Constance Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.5.3]
b. 24 Apr 1908 d. 23 Jul 1981
Julius Veggo Madsen
b. 16 May 1899 d. 15 Jun 1981
12
Connie Marie Madsen
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.5.3.1]
b. 11 Jul 1930 d. 27 Jul 2007
12
Franklin Benson Madsen
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.5.3.2]
b. 19 Jul 1934 d. 4 Apr 2011
11
Donna Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.5.4]
b. 16 Mar 1910 d. 5 Dec 1997
Lawrence Lee
b. 26 Jan 1903 d. 5 Jun 1976
12
Lawrence Benson Lee
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.5.4.1]
b. 8 Dec 1931 d. 7 Jun 2014
12
Karen Louise Lee
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.5.4.2]
b. 12 Dec 1933 d. 27 Mar 2005
12
Patricia Fae Lee
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.5.4.3]
b. 17 Jan 1937 d. 30 Jun 2017
12
Zetta Maurie Lee
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.5.4.4]
b. 18 Sep 1938 d. 10 Nov 1985 [
=>
]
11
Fae Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.5.5]
b. 14 Feb 1914 d. 9 Oct 1968
+
Wayne Jay Hansen
b. 28 Jan 1910 d. 22 Jun 1948
+
Mark Hamp Low
b. 23 Aug 1907 d. 5 Aug 1981
11
Zetta Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.5.6]
b. 20 Aug 1916 d. 6 Sep 2013
Edwin Loose Peterson
b. 27 Oct 1915 d. 19 Aug 1999
12
Living
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.5.6.1]
12
Lizette Peterson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.5.6.2]
b. 24 Feb 1951 d. 18 Jul 2002
12
Edwina Peterson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.5.6.3]
11
Theodore Nelson Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.5.7]
b. 1 Apr 1919 d. 27 Jan 2006
Margaret Jayne Todd
12
Kristen Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.5.7.1]
12
Elizabeth Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.5.7.2]
12
Carolinda Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.5.7.3]
11
Jacqueline Maurie Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.5.8]
b. 17 May 1925 d. 23 Apr 2019
+
Jay Richard Bell
b. 24 Jul 1925 d. 25 Mar 2010
10
Adeline Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.6]
b. 31 Jul 1879 d. 27 Jan 1960
Leo Peck
b. 28 Jun 1875 d. 12 Oct 1967
11
Florence Peck
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.6.1]
b. 1 May 1901 d. 23 Apr 1991
Grant Parkinson Packer
b. 12 Mar 1898 d. 23 Mar 1981
12
Grant Peck Packer
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.6.1.1]
b. 21 May 1925 d. 2 Jun 2008 [
=>
]
12
Leo Benson Packer
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.6.1.2]
b. 13 Nov 1927 d. 29 May 1974 [
=>
]
12
Margaret Catherine Packer
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.6.1.3]
b. 16 Aug 1930 d. 26 Nov 2015
12
Ossian Leonidas Packer
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.6.1.4]
b. 8 Dec 1932 d. 17 Aug 2015
12
Don Peck Packer
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.6.1.5]
12
Maurine Peck Packer
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.6.1.6]
b. 7 May 1940 d. 18 Apr 1995
12
David Packer
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.6.1.7]
12
Carla Rae Packer
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.6.1.8]
11
Effie Peck
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.6.2]
b. 8 Feb 1903 d. 21 Jul 1992
Alfred Walter Stevenson
b. 6 Oct 1900 d. 27 Nov 1974
12
Mitzi Stevenson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.6.2.1]
b. 14 Mar 1926 d. 12 Aug 2014
12
Patricia Stevenson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.6.2.2]
b. 4 Apr 1929 d. 17 Feb 2008
12
Walter Peck Stevenson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.6.2.3]
b. 17 Feb 1939 d. 21 Apr 2001
11
Leo Benson Peck
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.6.3]
b. 20 Jul 1905 d. 18 Nov 1917
11
Maurine Peck
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.6.4]
b. 22 Nov 1907 d. 4 Aug 1935
Kennett Highly Malan
b. 16 Apr 1904 d. 13 Apr 1977
12
Maurine Malan
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.6.4.1]
b. 13 May 1930 d. 13 May 1930
12
Kennett Darrett " Dart " Peck Malan
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.6.4.2]
b. 21 Aug 1931 d. 5 Apr 2010
12
Son Malan
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.6.4.3]
b. 2 Aug 1935 d. 2 Aug 1935
11
Beth Peck
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.6.5]
b. 24 Sep 1912 d. 8 Sep 2000
+
Ernest Hugh Ford
b. 1 Apr 1912 d. 27 Jan 2006
11
Garth Benson Peck
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.6.6]
b. 18 Apr 1916 d. 14 Dec 1993
+
Living
11
Olive Louise Peck
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.6.7]
b. 22 Jun 1920 d. 24 Aug 1993
Joseph Curran Foley
b. 19 Dec 1911 d. 9 Aug 2003
12
Living
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.6.7.1]
12
Living
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.6.7.2]
10
Florence Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.7]
b. 31 Jul 1879 d. 5 Nov 1967
Stanley Detlef Jonasson
b. 4 Mar 1878 d. 8 May 1959
11
Adeline Jonasson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.7.1]
b. 5 Nov 1906 d. 23 Jul 1975
+
Julius Louis Helvey
b. 14 Sep 1901 d. 15 Oct 1968
11
Stanley Taft Jonasson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.7.2]
b. 29 Aug 1908 d. 9 Dec 1986
+
Claire Anna Schneider
b. 22 Jun 1907 d. 22 Feb 1981
11
Helen Jonasson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.7.3]
b. 27 Sep 1910 d. 17 Oct 1931
11
Dorothy Jonasson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.7.4]
b. 1912 d. 1912
11
Alfred Benson ( Bill ) Jonasson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.7.5]
b. 26 Feb 1919 d. 16 Dec 2000
10
William Kennedy Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.8]
b. 9 Feb 1882 d. 28 Feb 1882
10
Frank Taft Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.9]
b. 23 Apr 1883 d. 19 Feb 1923
Elizabeth Greaves "Lillie" Eames
b. 6 Jun 1884 d. 28 Dec 1966
11
Gladys Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.9.1]
b. 12 Nov 1909 d. 27 Jan 1995
Don Giles Nelson
b. 8 Sep 1904 d. 25 Jan 1985
12
Kaye Fred Nelson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.9.1.1]
b. 10 Mar 1932 d. 11 Jun 2009 [
=>
]
12
Frankie Nelson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.9.1.2]
b. 1 Jan 1937 d. 22 Nov 2021 [
=>
]
12
Lorraine Nelson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.9.1.3]
b. 30 Dec 1943 d. 30 Jan 2016 [
=>
]
11
Carmen Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.9.2]
b. 4 Nov 1911 d. 17 Aug 2001
Robert Moss Lewis, Jr
b. 16 Mar 1909 d. 6 Jul 1985
12
Ann Lewis
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.9.2.1]
b. 20 Dec 1937 d. 7 Aug 2016
12
Colleen Lewis
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.9.2.2]
12
Robert Moss Lewis, III
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.9.2.3]
12
Harold Benson Lewis
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.9.2.4]
12
Carmen Lynne Lewis
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.9.2.5]
12
Elizabeth Lewis
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.9.2.6]
11
Harold Eames Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.9.3]
b. 4 Nov 1911 d. 20 Jul 1948
Shirley Anderson
b. 17 Aug 1929 d. 8 Aug 2015
12
Linda Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.9.3.1]
b. 10 Mar 1948 d. 14 Sep 2000 [
=>
]
11
Flora Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.9.4]
b. 30 Jan 1916 d. 14 Oct 1984
Lorin George Ransom
b. 8 Mar 1913 d. 14 Mar 1998
12
Lorin Gene Ransom
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.9.4.1]
12
Clair Benson Ransom
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.9.4.2]
12
Lee Ann Ransom
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.9.4.3]
12
George Benson Ransom
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.9.4.4]
11
Zenda Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.9.5]
b. 25 Oct 1918 d. 27 Feb 2003
Kember Dee Mabey
b. 24 May 1917 d. 21 Sep 1987
12
Paula Mabey
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.9.5.1]
12
T Dee Mabey
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.9.5.2]
12
Lynn Mabey
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.9.5.3]
12
Mark Mabey
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.9.5.4]
11
Frank Eames Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.9.6]
b. 26 Sep 1920 d. 2 Jan 1923
11
Nellie Louisa Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.9.7]
b. 11 Sep 1923 d. 11 Oct 1975
Louis Victor Christensen
b. 1 Oct 1922 d. 18 Mar 2011
12
Kathleen Christensen
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.9.7.1]
b. 16 Jan 1944 d. 16 Apr 2022
12
Dale Benson Christensen
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.9.7.2]
12
Michael Benson Christensen
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.9.7.3]
12
Frank Benson Christensen
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.9.7.4]
b. 19 Jun 1950 d. 2 Sep 1992
12
Kelly Benson Christensen
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.9.7.5]
b. 4 Jun 1954 d. 24 Jun 2006 [
=>
]
12
Ludean Benson Christensen
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.9.7.6]
12
David Benson Christensen
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.9.7.7]
12
Louis Benson Christensen
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.9.7.8]
b. 16 May 1960 d. 30 Apr 2020
10
Marie Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.10]
b. 19 Jul 1885 d. 6 Mar 1891
10
Carmen Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.11]
b. 7 Nov 1887 d. 5 Jul 1974
Franklin Brenneman Smith, Jr
b. Abt 1860 d. 11 Apr 1954
11
Franklin Breneman Smith, III
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.11.1]
b. 11 Jun 1923 d. 3 Apr 2009
11
Richard Benson Smith
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.11.2]
b. 15 Jun 1925 d. 8 Dec 2009
10
Jenny Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.12]
b. 30 Jun 1890 d. 12 Jul 1970
Earl Weaver
b. 22 Jun 1890 d. 11 Oct 1977
11
Kinnie Weaver
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.12.1]
b. 30 May 1916 d. 27 Aug 1999
+
Joseph Frederick Johnsen
b. 24 Apr 1913 d. 18 Jan 1999
11
Virginia Weaver
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.12.2]
b. 23 Dec 1917 d. 2012
+
Earl Midsland Kooyman
b. 24 Aug 1917 d. 8 Sep 1996
James Ross Reed, Jr
b. 10 Jan 1915 d. 3 Jan 1986
12
Peggy Jane Reed
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.12.2.1]
b. 22 Jun 1953 d. 21 Dec 2016
11
Mary Louise "Louie" Weaver
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.12.3]
b. 15 Jun 1921 d. 16 May 2012
Lynn John Lawrence
b. 25 Nov 1916 d. 25 Jul 2003
12
Mark Dugan Lawrence
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.12.3.1]
b. 1946 d. 2009
12
Steve Weaver Lawrence
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.12.3.2]
b. 1949 d. 2007
12
Rick Lawrence
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.12.3.3]
12
Kinnie Lawrence
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.12.3.4]
12
Brad Lawrence
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.12.3.5]
11
Earl Benson Weaver
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.12.4]
b. 27 Oct 1926 d. 1 Jan 2015
Barnara Ellen Smith
12
Melody Weaver
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.12.4.1]
[
=>
]
11
Jenalee Weaver
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.12.5]
b. 1929 d. Aug 2015
10
Kathinka "Kinnie" Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.13]
b. 15 Mar 1894 d. 20 May 1960
Robert Sweeten Holbrook
b. 14 Oct 1893 d. 2 Jun 1980
11
Robert Benson Holbrook
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.13.1]
b. 5 Aug 1917 d. 29 Feb 2000
Marjorie Ruth Kroescher
b. 24 Mar 1918 d. 12 Aug 2004
12
Brent Kroescher Holbrook
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.13.1.1]
b. 11 May 1956 d. 7 Dec 1974
11
George Benson Holbrook
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.13.2]
b. 3 Nov 1919 d. 7 Nov 2009
Norma Mowrey
b. 16 Aug 1921 d. 5 Nov 1999
12
Carol Ann Holbrook
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.13.2.1]
b. 3 Jul 1949 d. 25 Nov 2009
12
Dorothy Holbrook
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.13.2.2]
b. 26 Jun 1945 d. 26 Jun 1945
12
Bryan David Holbrook
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.13.2.3]
b. 5 Mar 1943 d. 5 Mar 1943
12
Kathleen Holbrook
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.13.2.4]
b. 6 Jan 1942 d. 6 Jan 1942
12
Daughter Holbrook
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.13.2.5]
b. 1944 d. 1944
11
Louise Holbrook
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.13.3]
b. 4 Jun 1912 d. 27 May 2009
Paul Jennings Callahan
b. 21 Jan 1912 d. 22 Jul 1982
12
Living
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.13.3.1]
12
Phillip Paul Callahan
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.13.3.2]
b. 10 Nov 1963 d. 19 Feb 2001
11
Donald Benson Holbrook
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.13.4]
b. 4 Feb 1925 d. 1 Mar 2005
12
Mark Donald Holbrook
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.13.4.1]
b. 11 Dec 1953 d. 27 Oct 1991
12
James Gregory Holbrook
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.13.4.2]
b. 19 Dec 1957 d. 26 May 1993
11
Gordon Benson Holbrook
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.13.5]
b. 22 Dec 1926 d. 2 Nov 1993
Claire Colleen Wamsley
b. 11 Apr 1926 d. 13 Oct 1978
12
Gordon Lee Holbrook
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.13.5.1]
b. 16 Aug 1950 d. 26 Aug 2000 [
=>
]
12
Susan Holbrook
[1.1.3.3.7.8.2.2.10.13.5.2]
b. 12 May 1948 d. 19 Jul 2002
+
Norma Louise Leston Strike
b. 29 Dec 1925 d. 25 Jul 1998
9
Florence Adeline Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.11]
b. 17 Sep 1851 d. 25 Dec 1852
9
Nellie Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.12]
b. 30 Nov 1851 d. 24 Jan 1885
9
Frank Andrus Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.13]
b. 16 Oct 1853 d. 5 May 1937
Amanda Charlotta Eliason
b. 4 Jun 1861 d. 12 Mar 1922
10
Eva A Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.13.1]
b. 6 Jul 1882 d. 10 Aug 1946
10
Blanche Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.13.2]
b. 7 May 1888 d. 12 Sep 1979
10
Edna Mae Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.13.3]
b. 19 Oct 1890 d. 19 Mar 1976
10
Frank Andrus Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.13.4]
b. 30 Apr 1895 d. 18 Dec 1968
10
Eleanora Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.13.5]
b. 30 Nov 1896 d. 2 Oct 1992
10
Karl Eliason Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.13.6]
b. 21 Apr 1899 d. 21 Oct 1980
10
Adeline Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.13.7]
b. 14 Mar 1904 d. 5 May 1904
10
George Taft Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.13.8]
b. 17 Aug 1905 d. 18 Feb 1942
9
Samuel Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.14]
b. 1853
Eliza Ann Perry
b. 30 Mar 1828 d. 30 Apr 1913
9
Alice Eliza Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.15]
b. 11 Aug 1848 d. 3 Jun 1923
9
John Perry Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.16]
b. 24 Sep 1849 d. 4 Jan 1921
9
Malina Adelaide Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.17]
b. 21 Sep 1851 d. 31 Jul 1918
9
Orrin William Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.18]
b. 4 Oct 1853 d. 17 May 1917
9
Carrie Stella Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.19]
b. 22 May 1860 d. 15 Mar 1928
9
Abbie Della Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.20]
b. 16 Oct 1862 d. 22 Oct 1925
9
Grace Ann Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.21]
b. 31 Jan 1867 d. 15 Dec 1924
Elizabeth Gollaher
b. 30 Dec 1831 d. 4 May 1904
9
Fredrick Gollaher Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.22]
b. 17 Jan 1855 d. 6 Jan 1915
9
Brigham Young Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.23]
b. 17 Dec 1858 d. 11 Jul 1938
9
Luella Gollaher Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.24]
b. 12 Nov 1860 d. 22 Jul 1881
9
William C Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.25]
b. 11 Nov 1862 d. Sep 1937
9
Hyrum Smith Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.26]
b. 3 May 1864 d. 4 May 1935
9
Edith Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.27]
b. 22 Apr 1867 d. 11 Feb 1925
9
Lizzie Gollaher Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.28]
b. 9 Jul 1869 d. 30 Jul 1946
Olive Mary Knight
b. 24 Jan 1830 d. 27 Mar 1905
9
Louisa Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.29]
b. 29 Jun 1852 d. 29 Nov 1878
9
Heber Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.30]
b. Abt 1860 d. Bef 1868
9
Moroni Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.31]
b. 5 Nov 1861 d. 8 Jan 1934
9
Lorenzo Taft Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.32]
b. 3 Aug 1863 d. 6 Nov 1950
9
Joseph Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.33]
b. 13 Jul 1865 d. 5 Jun 1941
9
Ida May Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.34]
b. 16 Apr 1867 d. 30 Jun 1929
9
Don Carlos Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.35]
b. 29 Sep 1869 d. 19 Jan 1935
Mary Marie Larsen
b. 19 Dec 1843 d. 21 Feb 1926
9
Walter Taft Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.36]
b. 17 Jun 1867 d. 6 Jun 1957
9
Henry Taft Benson
[1.1.3.3.7.8.2.2.37]
b. 19 Mar 1869 d. 24 Feb 1947
+
Desdemona Wadsworth Fullmer
b. 6 Oct 1809 d. 9 Feb 1886
+
Lucinda Burton
b. 22 Oct 1825 d. 1 Oct 1863
8
George Taft Benson
[1.1.3.3.7.8.2.3]
b. Abt 1813
Prudence Maria Gifford
b. Abt 1815
9
Walter Everet Benson
[1.1.3.3.7.8.2.3.1]
b. 13 Sep 1857 d. 29 Apr 1907
Laura Frances Caldwell
b. 1862
10
Laura Livice Benson
[1.1.3.3.7.8.2.3.1.1]
b. 9 Oct 1883 d. 14 Feb 1911
Robert K Plummer
b. 1848 d. 21 Sep 1930
11
Gertude K Plummer
[1.1.3.3.7.8.2.3.1.1.1]
b. 1903
11
George K Plummer
[1.1.3.3.7.8.2.3.1.1.2]
b. 1904
11
Nathan B Plummer
[1.1.3.3.7.8.2.3.1.1.3]
b. 24 Jan 1911 d. 16 Nov 1994
10
George T Benson
[1.1.3.3.7.8.2.3.1.2]
b. Feb 1885
+
Ida N Steele
b. 9 Jan 1885
8
Hannah Benson
[1.1.3.3.7.8.2.4]
b. 18 Sep 1816
Henry Dodge
b. 15 Dec 1812 d. 22 Jun 1883
9
John M Dodge
[1.1.3.3.7.8.2.4.1]
b. 1838 d. 14 Feb 1898
9
Abbie R Dodge
[1.1.3.3.7.8.2.4.2]
b. 1850 d. 27 Sep 1916
John Averell
b. 1846 d. 19 Aug 1895
10
Elizabeth Alice Averell
[1.1.3.3.7.8.2.4.2.1]
b. 13 Apr 1884 d. 4 Feb 1901
+
William Cotter Ball
b. 1865
8
Abbie Ann Benson
[1.1.3.3.7.8.2.5]
b. Abt 1809 d. 21 Sep 1883
Calvin Rawson
b. 13 May 1797 d. 21 Jan 1868
9
Son Rawson
[1.1.3.3.7.8.2.5.1]
b. Abt 1828 d. Abt 1838
8
John M Benson
[1.1.3.3.7.8.2.6]
b. 1819 d. 12 Aug 1829
7
Ezra Taft
[1.1.3.3.7.8.3]
b. 6 Mar 1793 d. 19 Feb 1808
3
Thomas Eastman
[1.1.4]
b. 11 Sep 1646 d. 29 Apr 1688
3
Timothy Eastman
[1.1.5]
b. 29 Sep 1648 d. 1 Apr 1733
3
Joseph Eastman
[1.1.6]
b. 8 Nov 1650 d. 4 Apr 1692
Mary Tilton
b. 18 Feb 1643 d. 11 Jul 1696
4
Joseph Eastman
[1.1.6.1]
b. 2 Aug 1683 d. 29 Sep 1769
4
Mary Eastman
[1.1.6.2]
b. 11 Dec 1684 d. 31 Mar 1711
4
Peter Eastman
[1.1.6.3]
b. 20 Jan 1686 d. 29 Sep 1769
Mehitable Root
b. 27 May 1688 d. 22 Nov 1783
5
Peter Eastman, Jr
[1.1.6.3.1]
b. 7 Sep 1709 d. 18 Feb 1767
Esther Laird
b. 1716 d. 10 Feb 1762
6
Polly Eastman
[1.1.6.3.1.1]
b. 1737 d. 1770
6
William Eastman
[1.1.6.3.1.2]
b. 1739 d. 1808
6
Tilton Eastman
[1.1.6.3.1.3]
b. 1741 d. 20 Jan 1805
6
Norman Eastman
[1.1.6.3.1.4]
b. Abt 1746
5
William Eastman
[1.1.6.3.2]
b. 5 Aug 1714 d. 29 Dec 1714
5
Hezekiah Eastman
[1.1.6.3.3]
b. 5 Feb 1716
5
Benjamin Eastman
[1.1.6.3.4]
b. Jan 1717 d. 6 Apr 1814
5
Azariah Eastman
[1.1.6.3.5]
b. 1718 d. 1777
5
Joseph Eastman
[1.1.6.3.6]
b. 9 Sep 1724 d. 15 Sep 1802
Phebe Hendricks
b. 1723 d. 4 Mar 1812
6
Hezekiah Eastman
[1.1.6.3.6.1]
b. 1 Sep 1748 d. 9 Sep 1831
Hannah Porter
b. 29 Mar 1751 d. 12 Aug 1820
7
Harvey Eastman
[1.1.6.3.6.1.1]
b. 8 Jul 1777 d. 8 Jul 1829
Anne Rundell
b. 9 Apr 1777 d. 25 Mar 1847
8
Rhoda Eastman
[1.1.6.3.6.1.1.1]
b. 9 Dec 1797 d. 19 Apr 1890
8
Lucy Eastman
[1.1.6.3.6.1.1.2]
b. 4 Oct 1801 d. 25 Feb 1877
8
Martin Luce Eastman
[1.1.6.3.6.1.1.3]
b. 8 Sep 1803 d. 12 Aug 1847
8
Almon Russell Eastman
[1.1.6.3.6.1.1.4]
b. 1805 d. 6 Apr 1873
8
Joseph Porter Eastman
[1.1.6.3.6.1.1.5]
b. 28 May 1805 d. 8 Oct 1888
8
Mary Ann Eastman
[1.1.6.3.6.1.1.6]
b. 1806 d. 14 Nov 1811
8
Horace Haviland Eastman
[1.1.6.3.6.1.1.7]
b. 27 Jun 1807 d. 29 Jun 1898
8
Erastus Harvey Eastman
[1.1.6.3.6.1.1.8]
b. 3 Sep 1812 d. 22 Sep 1839
8
Clarisa E Eastman
[1.1.6.3.6.1.1.9]
b. 5 Aug 1813 d. 25 Mar 1877
8
George Washington Eastman
[1.1.6.3.6.1.1.10]
b. 9 Sep 1815 d. 27 Apr 1862
Maria Kilbourn
b. 22 Aug 1821 d. 16 Jun 1907
9
Ellen Maria Eastman
[1.1.6.3.6.1.1.10.1]
b. 4 Nov 1845 d. 25 Jun 1884
9
Emma Kate Eastman
[1.1.6.3.6.1.1.10.2]
b. 6 Aug 1850 d. 3 Dec 1870
9
George Eastman
[1.1.6.3.6.1.1.10.3]
b. 12 Jul 1854 d. 14 Mar 1932
7
Buell Eastman
[1.1.6.3.6.1.2]
b. 1779 d. 1804
7
Sarah Eastman
[1.1.6.3.6.1.3]
b. 1785
7
Phebe Eastman
[1.1.6.3.6.1.4]
b. 1787 d. 5 Jan 1874
Benjamin W Potter
b. 10 May 1787 d. 30 Mar 1826
8
Lindorf G Potter
[1.1.6.3.6.1.4.1]
b. 22 Feb 1810 d. 25 Mar 1857
8
Milo Potter
[1.1.6.3.6.1.4.2]
b. 5 Jul 1812 d. 27 Jan 1813
8
Myron Potter
[1.1.6.3.6.1.4.3]
b. 20 Mar 1814 d. 10 Nov 1855
8
Milton Elon Potter
[1.1.6.3.6.1.4.4]
b. 5 Oct 1816 d. 1 Nov 1875
8
Phoebe Potter
[1.1.6.3.6.1.4.5]
b. 28 Jan 1819 d. 30 Mar 1819
8
Philo Welton Potter
[1.1.6.3.6.1.4.6]
b. 28 Feb 1820 d. 26 Apr 1891
8
Julia M Potter
[1.1.6.3.6.1.4.7]
b. 15 Sep 1823 d. 8 Oct 1899
7
Hannah Eastman
[1.1.6.3.6.1.5]
b. 1789
7
Sarah Eastman
[1.1.6.3.6.1.6]
b. 1791
6
Joseph Eastman
[1.1.6.3.6.2]
b. 21 Mar 1756 d. 25 Feb 1844
Hannah Martin Warner
b. 1767 d. 17 Jul 1832
7
Abigail Eastman
[1.1.6.3.6.2.1]
b. Abt 1786 d. 16 Nov 1842
7
Ruth Eastman
[1.1.6.3.6.2.2]
b. Abt 1789
7
Mary "Polly" Eastman
[1.1.6.3.6.2.3]
b. 1789 d. 17 Apr 1840
7
Nathan Warner Eastman
[1.1.6.3.6.2.4]
b. 1790 d. Oct 1869
7
Almira Eastman
[1.1.6.3.6.2.5]
b. Abt 1791
7
Sallina Eastman
[1.1.6.3.6.2.6]
b. 24 Mar 1792 d. 6 Feb 1841
7
Farzina Eastman
[1.1.6.3.6.2.7]
b. Abt 1796
7
Minerva Eastman
[1.1.6.3.6.2.8]
b. 27 May 1796 d. 31 Dec 1866
7
Andrew Squires Eastman
[1.1.6.3.6.2.9]
b. 25 Jan 1800 d. 11 Dec 1856
7
Emily Eastman
[1.1.6.3.6.2.10]
b. 1803 d. 1874
7
Electa Eastman
[1.1.6.3.6.2.11]
b. Abt 1804 d. 10 Oct 1844
7
Sophronia Eastman
[1.1.6.3.6.2.12]
b. 17 Mar 1806 d. 16 Jun 1900
7
Joseph Socrates Eastman
[1.1.6.3.6.2.13]
b. 24 Jun 1809 d. 19 Aug 1883
7
Achsah Eastman
[1.1.6.3.6.2.14]
b. Apr 1812
6
Phoebe Eastman
[1.1.6.3.6.3]
b. 1758 d. 1790
Paul Wellman
b. 15 Apr 1757 d. 1829
7
Barney Wellman
[1.1.6.3.6.3.1]
b. 1779
7
Joseph Wellman
[1.1.6.3.6.3.2]
b. Jan 1781 d. 29 Apr 1835
7
Manley Wellman
[1.1.6.3.6.3.3]
b. Abt 1784
7
Hezekiah Wellman
[1.1.6.3.6.3.4]
b. 25 Mar 1787 d. 15 Sep 1865
7
Phoebe Wellman
[1.1.6.3.6.3.5]
b. 5 Nov 1787 d. 26 Jan 1863
7
Miss Wellman
[1.1.6.3.6.3.6]
b. Abt 1790 d. 1791
6
Experience Eastman
[1.1.6.3.6.4]
b. 1762
Ephraim Conger
b. Abt 1760
7
Hanford Conger
[1.1.6.3.6.4.1]
b. 26 Dec 1787 d. 26 Nov 1875
7
Salina Conger
[1.1.6.3.6.4.2]
b. 1791 d. Abt 1872
7
Amaziah Conger
[1.1.6.3.6.4.3]
b. 1792 bur. Jun 1868
7
Ephraim Conger
[1.1.6.3.6.4.4]
b. 25 Oct 1795 d. 8 Aug 1847
7
Amanda Conger
[1.1.6.3.6.4.5]
b. 20 May 1800 d. 22 May 1877
7
Electa Conger
[1.1.6.3.6.4.6]
b. Abt 1803
6
Nathaniel Eastman
[1.1.6.3.6.5]
b. 9 Jan 1763 d. 1823
Naomi Rowley
b. 29 Oct 1763 d. Jun 1847
7
Sarah Eastman
[1.1.6.3.6.5.1]
b. Abt 1778 d. 1869
7
Salina Eastman
[1.1.6.3.6.5.2]
b. 7 Nov 1785 d. 10 Jan 1788
7
Deborah Eastman
[1.1.6.3.6.5.3]
b. 21 Jul 1787 d. 14 Aug 1833
7
Phebe Hendricks Eastman
[1.1.6.3.6.5.4]
b. 5 Jul 1789 bur. 1845
7
Nathaniel Eastman
[1.1.6.3.6.5.5]
b. 17 Jun 1792 d. 15 Aug 1861
7
Solomon Rowlee Eastman
[1.1.6.3.6.5.6]
b. 7 Jul 1796 d. 4 Nov 1881
7
Eliza Eastman
[1.1.6.3.6.5.7]
b. 10 Nov 1798 d. 1851
7
Mary Ann Eastman
[1.1.6.3.6.5.8]
b. 8 Sep 1805 d. 8 Feb 1847
6
John Eastman
[1.1.6.3.6.6]
b. 1765 d. 1828
Anna Kimball
b. Abt 1765
7
Appelles Eastman
[1.1.6.3.6.6.1]
b. 21 Oct 1800 d. 17 Nov 1869
7
Malintha Easman
[1.1.6.3.6.6.2]
b. 1801/1802 d. 25 Aug 1867
7
William Eastman
[1.1.6.3.6.6.3]
b. Abt 1802 d. 15 Aug 1845
7
Theron Eastman
[1.1.6.3.6.6.4]
b. 4 Sep 1805 d. 22 Apr 1862
7
Levi K Eastman
[1.1.6.3.6.6.5]
b. 1808 d. Bef 26 Sep 1853
7
John Eastman
[1.1.6.3.6.6.6]
b. Abt 1810
7
Lucy Eastman
[1.1.6.3.6.6.7]
b. Abt 1812
7
Lucy Ann Eastman
[1.1.6.3.6.6.8]
b. 1814 d. 1878
7
Anna Eastman
[1.1.6.3.6.6.9]
b. Abt 1815 d. 13 Mar 1895
7
Ameda Eastman
[1.1.6.3.6.6.10]
b. 1817 d. Abt 1848
7
Anna K Eastman
[1.1.6.3.6.6.11]
b. 1822 d. 13 Mar 1881
6
Peter Eastman
[1.1.6.3.6.7]
b. Abt 1765 d. 10 Oct 1850
Phebe Filmore
b. 1768 d. 9 Nov 1852
7
Matthew Eastman
[1.1.6.3.6.7.1]
b. 18 Dec 1787 d. 15 Mar 1865
7
Hannah Eastman
[1.1.6.3.6.7.2]
b. 1794 d. 20 Dec 1877
7
Phebe Eastman
[1.1.6.3.6.7.3]
b. 1794
7
Harvey Eastman
[1.1.6.3.6.7.4]
b. Abt 1801 d. 18 Feb 1896
7
Ferdinand Eastman
[1.1.6.3.6.7.5]
b. 1803 d. 21 Oct 1857
7
Huldah H. Eastman
[1.1.6.3.6.7.6]
b. 27 May 1804 d. 17 Jan 1875
6
Abraham Dayton Eastman
[1.1.6.3.6.8]
b. 24 Jun 1765 d. 25 Feb 1850
Ruth Rundell
b. 18 Apr 1772 d. 31 Mar 1849
7
Nathaniel Henry Eastman
[1.1.6.3.6.8.1]
b. 28 Dec 1791 d. 30 Jul 1867
7
William Rundell Eastman
[1.1.6.3.6.8.2]
b. 25 Nov 1793 d. 1885
7
Joseph Eastman
[1.1.6.3.6.8.3]
b. Abt 1796 d. 1878
7
Mahala Eastman
[1.1.6.3.6.8.4]
b. Abt 1806 d. 1896
7
Mary Ann Eastman
[1.1.6.3.6.8.5]
b. Abt 1808
5
Mehitable Eastman
[1.1.6.3.7]
b. 1728 d. 1824
5
Mary Eastman
[1.1.6.3.8]
b. 21 Mar 1710 d. 31 Mar 1710
3
Benjamin Eastman
[1.1.7]
b. 12 Dec 1652 d. 4 Mar 1728
3
Sarah Eastman
[1.1.8]
b. 25 Sep 1655 d. 1 Dec 1748
3
Samuel Eastman
[1.1.9]
b. 20 Sep 1657 d. 24 Feb 1725
3
Ruth Eastman
[1.1.10]
b. 21 Jan 1661 d. 24 Feb 1725