Home Page
|
What's New
|
Photos
|
Histories
|
Headstones
|
Reports
|
Surnames
Search
First Name:
Last Name:
Home
Search
Login
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
What's New
Most Wanted
Reports
Dates
Calendar
Cemeteries
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
All Media
Info
Statistics
Places
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Bookmarks
Contact Us
Print
Bookmark
English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Suomalainen
Svenska
Search
•
Advanced Search
•
Search Families
•
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Margaret Costard
1639 -
Individual
Descendants
Relationship
Timeline
Submit Photo / Doc
Worksheet
Family
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Margaret Costard
[1]
b. 1639
John Smith
b. 1635
2
John Smith
[1.1]
c. 21 Apr 1667
2
Elizabeth Smith
[1.2]
c. 1 Nov 1669 bur. 11 Oct 1737
John Bushnell
b. 8 Aug 1670 d. 21 Nov 1728
3
John Bushnell
[1.2.1]
c. 8 Aug 1697 bur. 23 Apr 1760
Mary Gustin
b. 1693 d. 3 Dec 1762
4
John Bushnell
[1.2.1.1]
c. 21 Sep 1718 d. 8 Jun 1786
Elizabeth
b. 1720 bur. 20 Nov 1806
5
James Bushnell
[1.2.1.1.1]
c. 23 Oct 1743
5
John Bushnell
[1.2.1.1.2]
c. 13 Apr 1746
5
Richard Bushnell
[1.2.1.1.3]
c. 29 May 1748 d. 2 Jun 1827
Elizabeth Harris
c. 31 May 1761 d. 23 Nov 1842
6
Martha Bushnell
[1.2.1.1.3.1]
c. 29 May 1783
6
Richard Bushnell
[1.2.1.1.3.2]
c. 1 May 1785 bur. 22 Aug 1827
Ann Gunson
c. 10 Jun 1787 d. Oct 1879
7
Mary Ann Bushnell
[1.2.1.1.3.2.1]
c. 2 Sep 1804
7
William Bushnell
[1.2.1.1.3.2.2]
b. 28 Oct 1808 d. 12 Aug 1832
7
Job Bushnell
[1.2.1.1.3.2.3]
b. 11 Mar 1811
7
Rich Bushnell
[1.2.1.1.3.2.4]
b. 1813 d. 1870
7
Stephen Bushnell
[1.2.1.1.3.2.5]
c. 1 Oct 1816 d. 5 May 1841
7
Sarah Bushnell
[1.2.1.1.3.2.6]
c. 11 Apr 1820
7
Robert Bushnell
[1.2.1.1.3.2.7]
c. 9 Nov 1823
7
Hannah Bushnell
[1.2.1.1.3.2.8]
c. 22 Oct 1825
6
Rebecca Bushnell
[1.2.1.1.3.3]
c. 25 Dec 1787 d. 2 Apr 1790
6
George Bushnell
[1.2.1.1.3.4]
c. 27 Dec 1789 d. 1 Dec 1859
Eleanor
b. 1786
7
Susan Bushnell
[1.2.1.1.3.4.1]
c. 1 Jan 1816
7
Eliza Bushnell
[1.2.1.1.3.4.2]
c. 2 Jan 1819
6
James Bushnell
[1.2.1.1.3.5]
c. 31 Jul 1791
6
John Bushnell
[1.2.1.1.3.6]
b. 1791 d. 3 Sep 1866
Elizabeth Collins
c. 19 Jun 1795 d. 8 Apr 1831
7
Jonathan Bushnell
[1.2.1.1.3.6.1]
c. 16 Jun 1816 d. 14 Nov 1816
7
William Bushnell
[1.2.1.1.3.6.2]
c. 7 Sep 1817 d. 26 Jan 1888
Maria Morris
b. 1820
8
Stephen Bushnell
[1.2.1.1.3.6.2.1]
b. 3 Apr 1842 d. 3 May 1846
8
Elizabeth Bushnell
[1.2.1.1.3.6.2.2]
b. 19 Apr 1846
8
Eliza Bushnell
[1.2.1.1.3.6.2.3]
b. 27 Dec 1847
8
Jane Bushnell
[1.2.1.1.3.6.2.4]
b. 11 Feb 1849
8
James Bushnell
[1.2.1.1.3.6.2.5]
b. 1850
8
Harriet Bushnell
[1.2.1.1.3.6.2.6]
b. 1852
8
Harry Bushnell
[1.2.1.1.3.6.2.7]
b. 1854
7
Helen Harriet Bushnell
[1.2.1.1.3.6.3]
b. 16 Jan 1818 d. 1894
7
Thomas Bushnell
[1.2.1.1.3.6.4]
c. 2 Apr 1820 d. 30 Sep 1820
7
James Bushnell
[1.2.1.1.3.6.5]
c. 19 Jun 1821 d. 30 May 1831
7
John H Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6]
b. 19 Apr 1823 d. 29 Jul 1882
Elizabeth Brockbank
b. 8 Nov 1838 d. 16 Sep 1926
8
John Brockbank Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1]
b. 23 Aug 1856 d. 29 May 1928
Francis Elizabeth Ferguson
b. 17 Sep 1861 d. 18 Jun 1938
9
John Delbert Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.1]
b. 26 May 1883 d. 7 Apr 1975
Martha Hannah Lees Fisher
b. 19 Feb 1882 d. 23 May 1958
10
Kelleth Delbert Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.1.1]
b. 12 Feb 1908 d. 21 Aug 1983
Elna Margaret Childs
b. 16 Oct 1912 d. 14 Feb 1970
11
JoAnne Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.1.1.1]
b. 23 Jun 1933 d. 18 Mar 2020
11
Howard Newell Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.1.1.2]
b. 23 Jun 1942 d. 30 Jan 2019
11
John Kelleth Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.1.1.3]
b. 5 Sep 1934 d. 24 Dec 2013
Joanne Knight
12
John Kevin Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.1.1.3.1]
Wanda Watts
b. 19 Feb 1931 d. 29 Jun 2017
12
Lori Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.1.1.3.2]
12
Jeff Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.1.1.3.3]
12
Denise Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.1.1.3.4]
+
Freida Agnes Robison
b. 24 Jul 1909 d. 14 Sep 1992
10
Wanda Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.1.2]
b. 22 Feb 1909 d. 28 Oct 2002
Carl Andrew Pulsipher
b. 8 Jun 1905 d. 17 Dec 1983
11
Melva Jean Pulsipher
[1.2.1.1.3.6.6.1.1.2.1]
b. 27 Dec 1931 d. 13 Oct 2007
Bigler
12
Kevin Scott Bigler
[1.2.1.1.3.6.6.1.1.2.1.1]
b. 21 Jul 1954 d. 18 Aug 1985
12
Todd Dennis Bigler
[1.2.1.1.3.6.6.1.1.2.1.2]
b. 29 Jan 1962 d. Dec 2011
11
Marva Lou Pulsipher
[1.2.1.1.3.6.6.1.1.2.2]
b. 11 Dec 1932 d. 26 Sep 1982
10
Joseph Avon Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.1.3]
b. 21 Apr 1910 d. 4 Jun 1988
Hazel Ruby Millet
b. 13 Nov 1912 d. 4 Jan 1942
11
Beverly Jean Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.1.3.1]
b. 5 Sep 1931 d. 15 Mar 2012
+
Delbert Taylor
11
Colleen Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.1.3.2]
b. 11 Jul 1934 d. 12 Nov 2010
+
Larry Evan Anderson
b. 20 Jan 1930 d. 18 Jan 2004
Kenneth Eugene Holcomb
b. 18 Jan 1931 d. 21 Jul 2010
12
Wendy Holcomb
[1.2.1.1.3.6.6.1.1.3.2.1]
b. 3 May 1962 d. 24 Dec 1982
11
Yvonne Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.1.3.3]
b. 4 Jan 1937 d. 7 Dec 2003
Ross David Melville
12
Byron Dirk Melville
[1.2.1.1.3.6.6.1.1.3.3.1]
b. 27 Jan 1957 d. 31 Jan 1957
12
Lanny Melville
[1.2.1.1.3.6.6.1.1.3.3.2]
12
Stephanie Melville
[1.2.1.1.3.6.6.1.1.3.3.3]
[
=>
]
12
Darwin Melville
[1.2.1.1.3.6.6.1.1.3.3.4]
12
Edwin Melville
[1.2.1.1.3.6.6.1.1.3.3.5]
12
Marcus Melville
[1.2.1.1.3.6.6.1.1.3.3.6]
12
Isaac Melville
[1.2.1.1.3.6.6.1.1.3.3.7]
11
Marlene Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.1.3.4]
b. 23 Mar 1933 d. 2 Nov 2016
+
Ross Peterson
11
Bonita Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.1.3.5]
11
Lowry Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.1.3.6]
+
Becky
+
Iva Beth Lowry
b. 31 Mar 1916 d. 14 Feb 1997
+
Lessie Maggie Shelton
b. 20 Jun 1918 d. 19 Mar 2005
10
Linda Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.1.4]
b. 23 Nov 1912 d. 25 May 2001
James Ellis Yardley
b. 6 Nov 1904 d. 19 Feb 1990
11
Rhea Dean Yardley
[1.2.1.1.3.6.6.1.1.4.1]
b. 13 Sep 1932 d. 24 Mar 2004
James Ray Dean
b. 10 Jan 1930 d. 4 Apr 2006
12
Kimberlee Ann Dean
[1.2.1.1.3.6.6.1.1.4.1.1]
b. 17 May 1953 d. 16 Aug 2003
11
Joseph Ellis Yardley
[1.2.1.1.3.6.6.1.1.4.2]
b. 8 Jul 1934 d. 31 Oct 1996
11
Martha Ann Yardley
[1.2.1.1.3.6.6.1.1.4.3]
b. 26 Jul 1935 d. 21 Nov 2011
+
Dale McRae Swindlehurst
b. 2 Jul 1936 d. 22 Sep 2012
10
Elizabeth Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.1.5]
b. 11 Nov 1923 d. 27 Apr 1970
+
Allen B Taylor
b. 7 Jan 1920 d. 19 Jun 1987
+
Sarah Isabell McPhie
b. 16 Jan 1891 d. 1982
9
Isaac Ernest Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.2]
b. 18 Mar 1885 d. 9 Jul 1947
Edith Ann Bennett
b. 3 Jan 1885 d. 9 Jul 1947
10
Weldo Bell Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.2.1]
b. 15 May 1908 d. 28 Nov 1972
Lenna Jane Rowley
b. 3 May 1919 d. 20 Oct 1999
11
Betty Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.2.1.1]
11
Roger David Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.2.1.2]
11
Weldo Cleve Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.2.1.3]
11
Candyce Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.2.1.4]
11
Ladd R Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.2.1.5]
10
Edith Loretta Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.2.2]
b. 19 Sep 1909 d. 3 Mar 2000
Ellis Varvilla Taft
b. 4 Jun 1900 d. 8 May 1985
11
Ada Bushnell Taft
[1.2.1.1.3.6.6.1.2.2.1]
b. 4 May 1932 d. 25 Jul 1970
Donald Hector Mills
b. 10 Mar 1926 d. 6 Sep 2003
12
Donna Mills
[1.2.1.1.3.6.6.1.2.2.1.1]
b. 14 Jul 1949 d. 13 Apr 2012
11
Ellis Mason Taft
[1.2.1.1.3.6.6.1.2.2.2]
b. 4 Sep 1933 d. 26 May 2010
11
Dee Taft
[1.2.1.1.3.6.6.1.2.2.3]
b. 28 Mar 1948 d. 28 Mar 1948
10
Belva E Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.2.3]
b. 31 Oct 1910 d. 4 Mar 1995
William Harold Stewart
b. 30 Jun 1909 d. 25 Aug 1996
11
Aldean Stewart
[1.2.1.1.3.6.6.1.2.3.1]
b. 9 Mar 1930 d. 6 Nov 1999
Ina Collier
b. 1 Oct 1935 d. 7 Mar 1997
12
Harold Dean Stewart
[1.2.1.1.3.6.6.1.2.3.1.1]
12
Larry Jay Stewart
[1.2.1.1.3.6.6.1.2.3.1.2]
12
Neldon Ray Stewart
[1.2.1.1.3.6.6.1.2.3.1.3]
12
Sherrie Stewart
[1.2.1.1.3.6.6.1.2.3.1.4]
12
Pamela Stewart
[1.2.1.1.3.6.6.1.2.3.1.5]
11
Kent Stewart
[1.2.1.1.3.6.6.1.2.3.2]
b. 29 Sep 1931 d. 2 May 1978
Sharon
12
Janet Stewart
[1.2.1.1.3.6.6.1.2.3.2.1]
12
Vickie Stewart
[1.2.1.1.3.6.6.1.2.3.2.2]
12
Mark Kent Stewart
[1.2.1.1.3.6.6.1.2.3.2.3]
b. 23 Feb 1956 d. 11 Feb 1979
12
Connie Stewart
[1.2.1.1.3.6.6.1.2.3.2.4]
12
Kevin Stewart
[1.2.1.1.3.6.6.1.2.3.2.5]
12
Lisa Stewart
[1.2.1.1.3.6.6.1.2.3.2.6]
11
Frances Stewart
[1.2.1.1.3.6.6.1.2.3.3]
11
Vern Stewart
[1.2.1.1.3.6.6.1.2.3.4]
11
LaVon Stewart
[1.2.1.1.3.6.6.1.2.3.5]
b. 17 Apr 1949 d. 28 Mar 2003
Stephens
12
Vernon Stephens
[1.2.1.1.3.6.6.1.2.3.5.1]
12
Brenda Stephens
[1.2.1.1.3.6.6.1.2.3.5.2]
12
Travis Stephens
[1.2.1.1.3.6.6.1.2.3.5.3]
12
Stephanie Melissa Stephens
[1.2.1.1.3.6.6.1.2.3.5.4]
b. 22 Jan 1971 d. 22 Jan 1971
12
Daniel Stephens
[1.2.1.1.3.6.6.1.2.3.5.5]
10
Ural J Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.2.4]
b. 19 Feb 1912 d. 22 Sep 1975
Lola Forsyth
b. 23 Apr 1917 d. 23 Jul 1969
11
Clell F Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.2.4.1]
b. 24 Apr 1936 d. 13 Sep 1957
10
Beatrice Vernell Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.2.5]
b. 17 Mar 1917 d. 31 Jul 1997
Edgar J Stewart
b. 27 Jul 1915 d. 11 Mar 1973
11
Vernell Stewart
[1.2.1.1.3.6.6.1.2.5.1]
b. 7 Jan 1935 d. 19 Jun 2016
Calvin Jay Dutson
b. 11 May 1928 d. 16 Nov 2011
12
Jay Emery Dutson
[1.2.1.1.3.6.6.1.2.5.1.1]
b. 10 Sep 1958 d. 15 Nov 1995
11
Ramon Stewart
[1.2.1.1.3.6.6.1.2.5.2]
b. 18 Mar 1938 d. 8 Dec 2010
11
Edward Bushnell Stewart
[1.2.1.1.3.6.6.1.2.5.3]
b. 14 Feb 1947 d. 4 Jan 2005
+
Von Lon Tidwell
b. 13 Oct 1913 d. 1 Apr 2001
10
Ruth Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.2.6]
b. 7 Oct 1919 d. 4 Feb 2006
+
Conway Evelyn Parry
b. 26 Aug 1912 d. 25 Apr 1999
10
Lola B Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.2.7]
b. 25 Feb 1914 d. 14 Jan 1997
+
Leonard Henry Knoles
b. 6 Jul 1910 d. 2001
McClane Penney
b. 30 Sep 1907 d. 20 Aug 1941
11
Fay William Penney
[1.2.1.1.3.6.6.1.2.7.1]
b. 26 Sep 1935 d. 26 Jun 1993
11
Chell M Penney
[1.2.1.1.3.6.6.1.2.7.2]
b. 20 Oct 1938 d. 20 Oct 1938
9
Amy Elizabeth Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.3]
b. 20 Dec 1886 d. 24 Aug 1974
Hyrum Vincent Adams
b. 23 Mar 1885 d. 25 Oct 1948
10
LaVerre Vincent Adams
[1.2.1.1.3.6.6.1.3.1]
b. 11 May 1906 d. 20 May 1982
+
Nancy May Ferrin
b. 7 Mar 1904 d. 17 Jan 2002
10
Leland Bushnell Adams
[1.2.1.1.3.6.6.1.3.2]
b. 9 Oct 1907 d. 13 Dec 1976
Eloise Hansen
b. 17 Jul 1905 d. 24 Sep 1994
11
Leland Vee Adams
[1.2.1.1.3.6.6.1.3.2.1]
b. 19 Jul 1930 d. 19 Jul 1930
11
Douglas William Adams
[1.2.1.1.3.6.6.1.3.2.2]
b. 11 Nov 1931 d. 23 Mar 2003
Rose Marie Platt
b. 18 Sep 1931 d. 17 Sep 1986
12
Natalie Adams
[1.2.1.1.3.6.6.1.3.2.2.1]
b. 9 Dec 1956 d. 28 Mar 1978
11
Barbara Jean Adams
[1.2.1.1.3.6.6.1.3.2.3]
b. 4 Mar 1933 d. 17 Dec 2009
11
John Darrel Adams
[1.2.1.1.3.6.6.1.3.2.4]
b. 26 Aug 1935 d. 1 Feb 1937
11
Melvin Leroy Adams
[1.2.1.1.3.6.6.1.3.2.5]
b. 15 Feb 1940 d. 14 Jul 1982
11
Robert Adams
[1.2.1.1.3.6.6.1.3.2.6]
11
Gary Lee Adams
[1.2.1.1.3.6.6.1.3.2.7]
b. 29 Sep 1945 d. 8 Jan 1980
10
Loyd Hyrum Adams
[1.2.1.1.3.6.6.1.3.3]
b. 24 Mar 1910 d. 21 Dec 1965
Genevieve Williams
b. 29 Nov 1914 d. 11 Apr 2007
11
Raymond J Adams
[1.2.1.1.3.6.6.1.3.3.1]
b. 22 Jun 1947 d. 27 Sep 2002
10
Idonna Adams
[1.2.1.1.3.6.6.1.3.4]
b. 3 Mar 1912 d. 26 Jun 1997
+
Tyrrell Squires Toone
b. 16 Oct 1903 d. 17 Jan 1997
10
Vanetta Adams
[1.2.1.1.3.6.6.1.3.5]
b. 16 Aug 1913 d. 6 Feb 1990
Marion Yergensen Robison
b. 17 Jul 1911 d. 27 Sep 1971
11
Ida Faye Robison
[1.2.1.1.3.6.6.1.3.5.1]
b. 19 Apr 1934 d. 17 Nov 2002
+
John Hyrum Timpson
b. 3 Jul 1932 d. 27 Dec 1977
11
Mark Jay Robison
[1.2.1.1.3.6.6.1.3.5.2]
b. 6 Nov 1943 d. 16 Oct 1986
10
Luella Adams
[1.2.1.1.3.6.6.1.3.6]
b. 10 Dec 1916 d. 4 Apr 1997
Jarold Duncan Edwards
b. 17 Nov 1914 d. 21 May 1981
11
Monte Gerald Edwards
[1.2.1.1.3.6.6.1.3.6.1]
b. 14 Nov 1935 d. 19 Jan 2010
11
Val Dean Edwards
[1.2.1.1.3.6.6.1.3.6.2]
b. 24 Oct 1940 d. 29 Aug 2008
Deanna Duncan
b. 29 Jan 1938 d. 28 Nov 2009
12
Wendy Belle Edwards
[1.2.1.1.3.6.6.1.3.6.2.1]
12
Kelly Dean Edwards
[1.2.1.1.3.6.6.1.3.6.2.2]
12
Jody Val Edwards
[1.2.1.1.3.6.6.1.3.6.2.3]
12
Amy Lue Edwards
[1.2.1.1.3.6.6.1.3.6.2.4]
12
Ronald Arlyn Edwards
[1.2.1.1.3.6.6.1.3.6.2.5]
11
Larry V Edwards
[1.2.1.1.3.6.6.1.3.6.3]
11
Jerry Lue Edwards
[1.2.1.1.3.6.6.1.3.6.4]
11
Alice Janell Edwards
[1.2.1.1.3.6.6.1.3.6.5]
10
Mark J Adams
[1.2.1.1.3.6.6.1.3.7]
b. 28 Nov 1918 d. 23 Jun 1965
+
Marjorie Nora Miller
b. 8 Nov 1919 d. 2 Sep 1941
10
Alice Adams
[1.2.1.1.3.6.6.1.3.8]
b. 12 Mar 1921 d. 27 Dec 1929
10
Colleen Adams
[1.2.1.1.3.6.6.1.3.9]
b. 13 Nov 1926 d. 17 May 2020
+
Henry Anthony Paxton
b. 17 Dec 1925 d. 4 Apr 2020
9
Mary Ethel Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.4]
b. 26 Aug 1888 d. 27 Mar 1941
Harry Alchane Johnson
b. 6 Dec 1886 d. 2 Feb 1972
10
Viola Johnson
[1.2.1.1.3.6.6.1.4.1]
b. 12 Jun 1910 d. 12 Mar 1994
+
Walter Brinkerhoff
b. 30 Dec 1906 d. 7 May 2000
10
John Avalon Johnson
[1.2.1.1.3.6.6.1.4.2]
b. 26 Jan 1912 d. 21 Jul 2000
Agnes Oral Johnson
b. 2 Aug 1917 d. 18 Feb 2011
11
Rayma Johnson
[1.2.1.1.3.6.6.1.4.2.1]
11
Harry A Johnson
[1.2.1.1.3.6.6.1.4.2.2]
b. 19 Jan 1938 d. 25 Sep 1938
11
Merrill Johnson
[1.2.1.1.3.6.6.1.4.2.3]
11
Janna Johnson
[1.2.1.1.3.6.6.1.4.2.4]
b. 30 Oct 1943 d. 29 Dec 2021
11
Phyl Johnson
[1.2.1.1.3.6.6.1.4.2.5]
11
Linnae Johnson
[1.2.1.1.3.6.6.1.4.2.6]
10
Maurine Johnson
[1.2.1.1.3.6.6.1.4.3]
b. 17 Sep 1914 d. 2 Apr 1952
Bruce John Allen
b. 11 Apr 1911 d. 23 Sep 1969
11
Wilma Allen
[1.2.1.1.3.6.6.1.4.3.1]
b. 13 Dec 1933 d. 16 Sep 1950
+
Clark Walters Terrell
b. 22 May 1937 d. 17 May 2004
11
Phylis Allen
[1.2.1.1.3.6.6.1.4.3.2]
b. 22 Apr 1936 d. 12 Dec 2012
+
Dale Ronald Freeland
b. 19 Mar 1932 d. 22 Jul 2004
10
Velma Johnson
[1.2.1.1.3.6.6.1.4.4]
b. 15 Aug 1916 d. 28 Jun 1974
Edward Richard Blevins
b. 3 Oct 1913 d. 25 Oct 1968
11
James Edward Blevins
[1.2.1.1.3.6.6.1.4.4.1]
b. 15 May 1943 d. 28 Aug 2010
10
Eda Idell Johnson
[1.2.1.1.3.6.6.1.4.5]
b. 26 Nov 1918 d. 15 Nov 1963
Vernon Keith Horning
b. 22 Aug 1916 d. 15 Jan 2008
11
Robert Earl Horning
[1.2.1.1.3.6.6.1.4.5.1]
b. 13 Mar 1941 d. 19 Jun 1985
11
Son Horning
[1.2.1.1.3.6.6.1.4.5.2]
b. 1945 d. 1945
10
Loanda Johnson
[1.2.1.1.3.6.6.1.4.6]
b. 4 Feb 1921 d. 14 Sep 2012
+
Wesley Lloyd Roberts
b. 5 Apr 1918 d. 13 Mar 2007
10
Twyla Johnson
[1.2.1.1.3.6.6.1.4.7]
b. 20 Dec 1922 d. 9 Dec 1995
+
Alfred Eugene Swallow
b. 15 May 1917 d. 3 Mar 1989
10
Ethel Dot Johnson
[1.2.1.1.3.6.6.1.4.8]
b. 19 Jan 1925 d. 18 Apr 2016
10
Reva Joy Johnson
[1.2.1.1.3.6.6.1.4.9]
b. 11 Jun 1927 d. 20 Aug 2016
+
Oliver Ray Miller
b. 27 Sep 1926 d. 7 Aug 2015
9
William Emmett Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.5]
b. 14 Oct 1890 d. 11 Oct 1962
Lois Emma Duncan
b. 11 Jan 1894 d. 18 Mar 1981
10
Cleo Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.5.1]
b. 4 Dec 1916 d. 26 Mar 2011
Leroy L Labrum
b. 26 Jun 1912 d. 30 Jan 1977
11
Stephen LeRoy Labrum
[1.2.1.1.3.6.6.1.5.1.1]
b. 25 Feb 1947 d. 6 Jul 1988
12
Aaron LeRoy Labrum
[1.2.1.1.3.6.6.1.5.1.1.1]
+
Patricia Susan Hitt
b. 23 Jun 1953 d. 22 May 2011
11
Connie Labrum
[1.2.1.1.3.6.6.1.5.1.2]
+
Max Keetch
11
Kaye Labrum
[1.2.1.1.3.6.6.1.5.1.3]
+
Craig Baxter
11
LaRayne Labrum
[1.2.1.1.3.6.6.1.5.1.4]
+
Bruce Brown
10
Fae Elna Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.5.2]
b. 22 Jul 1918 d. 27 Jun 1996
Howard Walter Schmutz
b. 26 Jun 1919 d. 28 Aug 1995
11
Howard Walter Schmutz, Jr
[1.2.1.1.3.6.6.1.5.2.1]
b. 18 Sep 1942 d. 14 Jun 2013
Carol
12
Michelle Schmutz
[1.2.1.1.3.6.6.1.5.2.1.1]
12
Howard W Schmutz
[1.2.1.1.3.6.6.1.5.2.1.2]
12
Sherry Schmutz
[1.2.1.1.3.6.6.1.5.2.1.3]
12
Krista Schmutz
[1.2.1.1.3.6.6.1.5.2.1.4]
11
Duane B Schmutz
[1.2.1.1.3.6.6.1.5.2.2]
11
Dale J Schmutz
[1.2.1.1.3.6.6.1.5.2.3]
11
Janice Schmutz
[1.2.1.1.3.6.6.1.5.2.4]
10
Sargeant J LaMar Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.5.3]
b. 4 Dec 1920 d. 12 Aug 1944
10
Melvin J Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.5.4]
b. 30 Jul 1922 d. 29 Sep 1992
Marie Robins Frampton
b. 21 Dec 1926 d. 23 Jan 2015
11
Randall Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.5.4.1]
11
Kim Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.5.4.2]
+
Barbara
11
Lisa Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.5.4.3]
+
Stephen Andrues
+
Anna Josephine Jacketta
b. 8 Apr 1932 d. 6 Mar 2007
10
Lois LaVon Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.5.5]
b. 28 Jul 1923 d. 4 Jan 1994
Boyd Creer Roberts
b. 10 May 1926 d. 20 Jan 2011
11
Rita Roberts
[1.2.1.1.3.6.6.1.5.5.1]
+
Don James
11
Janna Lois Roberts
[1.2.1.1.3.6.6.1.5.5.2]
+
Brad Johnson
10
William Glen Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.5.6]
b. 28 May 1925 d. 11 Jan 2013
Velma Joy McBride
b. 15 Jul 1927 d. 30 Apr 1987
11
Living
[1.2.1.1.3.6.6.1.5.6.1]
+
Living
11
Sheri Joy Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.5.6.2]
b. 20 May 1961 d. 18 Mar 2003
Jon E Bischoff
12
Amanda Bischoff
[1.2.1.1.3.6.6.1.5.6.2.1]
12
Sarah Bischoff
[1.2.1.1.3.6.6.1.5.6.2.2]
11
Living
[1.2.1.1.3.6.6.1.5.6.3]
11
Living
[1.2.1.1.3.6.6.1.5.6.4]
10
Norma Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.5.7]
b. 18 Sep 1926 d. 17 Jun 2019
+
Cecil Dean George
b. 15 Jan 1928 d. 11 Jul 2020
9
Luella Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.6]
b. 13 Dec 1896 d. 28 Feb 1955
Lloyd Nadine Nickle
b. 11 Aug 1897 d. 15 Jun 1951
10
Albert J Nickle
[1.2.1.1.3.6.6.1.6.1]
b. 6 Nov 1919 d. 2 Sep 2015
10
James L Nickle
[1.2.1.1.3.6.6.1.6.2]
b. 22 Apr 1921 d. 4 Oct 1978
10
Rosebeath Nickle
[1.2.1.1.3.6.6.1.6.3]
b. 14 Jul 1923 d. 8 Dec 2014
9
Velma Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.7]
b. 11 Jul 1899 d. 10 Dec 1985
Joseph Leo Stott
b. 28 Oct 1894 d. 25 Aug 1959
10
Nadine Stott
[1.2.1.1.3.6.6.1.7.1]
b. 4 May 1918 d. 2 Nov 2005
Glade Riley Day
b. 29 Jun 1918 d. 23 Aug 2006
11
Tom Leo Day
[1.2.1.1.3.6.6.1.7.1.1]
b. 10 Nov 1945 d. 26 Aug 2012
Maryann Burdett
b. 26 Oct 1949 d. 11 May 1973
12
Jason Riley Day
[1.2.1.1.3.6.6.1.7.1.1.1]
b. 11 May 1973 d. 17 May 1973
10
Leola Stott
[1.2.1.1.3.6.6.1.7.2]
b. 8 Aug 1920 d. 26 Mar 2012
+
Lloyd Preal George
b. 17 Sep 1920 d. 13 May 1996
10
Stella Vee Stott
[1.2.1.1.3.6.6.1.7.3]
b. 8 Nov 1922 d. 16 Feb 2006
Chester Rogers Johnson
b. 20 Jan 1920 d. 11 Dec 2007
11
Living
[1.2.1.1.3.6.6.1.7.3.1]
+
Garth Frehner
11
Living
[1.2.1.1.3.6.6.1.7.3.2]
+
William Reed
11
Diane Johnson
[1.2.1.1.3.6.6.1.7.3.3]
b. 15 Apr 1945 d. 14 Apr 2016
+
James Buckwalter
11
Living
[1.2.1.1.3.6.6.1.7.3.4]
+
Michael Agee
11
Mark Ken Johnson
[1.2.1.1.3.6.6.1.7.3.5]
b. 13 Sep 1951 d. 15 Oct 2016
+
Shauna
11
Jeff Johnson
[1.2.1.1.3.6.6.1.7.3.6]
+
Stacy
10
Leo Ben Stott
[1.2.1.1.3.6.6.1.7.4]
b. 12 Jun 1931 d. 13 Jun 2003
Living
11
Colette Stott
[1.2.1.1.3.6.6.1.7.4.1]
+
Phil Mitchell
11
Camille Stott
[1.2.1.1.3.6.6.1.7.4.2]
b. 2 Apr 1954 d. 24 Aug 1967
11
Michael Ben Stott
[1.2.1.1.3.6.6.1.7.4.3]
+
Pam
11
Leo Dean Stott
[1.2.1.1.3.6.6.1.7.4.4]
+
Elizabeth
11
Douglas Keith Stott
[1.2.1.1.3.6.6.1.7.4.5]
+
Marilyn
10
Joseph B Stott
[1.2.1.1.3.6.6.1.7.5]
b. 16 May 1925 d. 20 Mar 2014
+
Joan Ileen Stewart
b. 10 Mar 1930 d. 27 May 2020
10
Norena M Stott
[1.2.1.1.3.6.6.1.7.6]
b. 21 Jun 1927 d. 9 Apr 2018
Jerald Ray Warner
b. 4 Oct 1927 d. 24 Mar 2003
11
Jerald Dean Warner
[1.2.1.1.3.6.6.1.7.6.1]
b. 1 Nov 1949 d. 22 May 2006
10
Reah Knoll Stott
[1.2.1.1.3.6.6.1.7.7]
b. 3 Aug 1933 d. 11 Sep 2017
+
Rowley
9
Barnard Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.8]
b. 6 Jan 1902 d. 6 Sep 1980
Phebe Ingrid Taylor
b. 29 Oct 1911 d. 26 May 1999
10
John Bernard Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.8.1]
b. 6 Feb 1936 d. 1 Oct 1983
Irene Deloris Olsen
b. 19 Jul 1940 d. 15 Jan 2000
11
LeR Douglas Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.8.1.1]
b. 20 Dec 1965 d. 16 Mar 2000
10
Velma Marie Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.8.2]
b. 1 Sep 1939 d. 15 Sep 2015
10
Lorene Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.1.8.3]
b. 8 Sep 1942 d. 30 Jun 2008
8
Isaac Brockbank Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.2]
b. 28 Sep 1858 d. 29 May 1877
+
Arizona Ferguson
b. 30 Jun 1865 d. 7 Dec 1878
+
Louisa Clara Franklin
b. Feb 1860 d. 10 May 1878
8
Edward Brockbank Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.3]
b. 2 Jul 1860 d. 22 Feb 1935
Catherine Hayes Dame
b. 17 Apr 1861 d. 9 Sep 1947
9
Lovina Elizabeth Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.3.1]
b. 22 Oct 1880 d. 25 Nov 1967
Hyrum Jesse Bond
b. 28 May 1868 d. 7 Nov 1938
10
Clinton Jesse Bond
[1.2.1.1.3.6.6.3.1.1]
b. 26 Oct 1905 d. 12 Apr 1994
Medra Alice Labrum
b. 26 Sep 1910 d. 15 Oct 2000
11
Terrill J Bond
[1.2.1.1.3.6.6.3.1.1.1]
b. 13 Sep 1931 d. 31 Jul 2009
Iris Charlesworth
b. 6 Apr 1931 d. 11 Feb 2022
12
Sharla Sue Bond
[1.2.1.1.3.6.6.3.1.1.1.1]
12
Terri Jan Bond
[1.2.1.1.3.6.6.3.1.1.1.2]
12
Terrill Lynn Bond
[1.2.1.1.3.6.6.3.1.1.1.3]
12
Carma Bond
[1.2.1.1.3.6.6.3.1.1.1.4]
11
Junior Labrum Bond
[1.2.1.1.3.6.6.3.1.1.2]
b. 22 Jul 1933 d. 29 Nov 1985
+
Living
11
Louise Bond
[1.2.1.1.3.6.6.3.1.1.3]
+
Jerrold Warner
10
Della Ann Bond
[1.2.1.1.3.6.6.3.1.2]
b. 8 Nov 1906 d. 28 Dec 1994
Nolan Henry Bennett
b. 19 Oct 1905 d. 2 Jan 1996
11
Deonna Ann Bennett
[1.2.1.1.3.6.6.3.1.2.1]
b. 21 May 1932 d. 22 Dec 2013
Joseph Gale Larsen
b. 13 Apr 1930 d. 16 Dec 1986
12
Jaren Larsen
[1.2.1.1.3.6.6.3.1.2.1.1]
12
Letitia Larsen
[1.2.1.1.3.6.6.3.1.2.1.2]
12
Cameron Larsen
[1.2.1.1.3.6.6.3.1.2.1.3]
12
Marcella Larsen
[1.2.1.1.3.6.6.3.1.2.1.4]
11
Boyd Nolan Bennett
[1.2.1.1.3.6.6.3.1.2.2]
b. 31 May 1936 d. 26 Jun 1985
11
Marlene Bennett
[1.2.1.1.3.6.6.3.1.2.3]
10
Maesa Ellen Bond
[1.2.1.1.3.6.6.3.1.3]
b. 21 Jan 1908 d. 2 Mar 1970
10
Edna Viola Bond
[1.2.1.1.3.6.6.3.1.4]
b. 16 Apr 1909 d. 6 Aug 2002
10
Son Bond
[1.2.1.1.3.6.6.3.1.5]
b. Abt 1911 d. Abt 1911
10
Willa Venetta Bond
[1.2.1.1.3.6.6.3.1.6]
b. 8 May 1911 d. 2 Nov 2010
10
Calvin Le Roy Bond
[1.2.1.1.3.6.6.3.1.7]
b. 25 Aug 1913 d. 30 Oct 1982
10
Hyrum Lemoine Bond
[1.2.1.1.3.6.6.3.1.8]
b. 12 Jun 1917 d. 14 Jul 2002
+
Luke Nield Stott
b. 11 Oct 1868 d. 20 Dec 1958
Hyrum Jesse Bond
b. 28 May 1868 d. 7 Nov 1938
10
Clinton Jesse Bond
[1.2.1.1.3.6.6.3.1.9]
b. 26 Oct 1905 d. 12 Apr 1994
10
Della Ann Bond
[1.2.1.1.3.6.6.3.1.10]
b. 8 Nov 1906 d. 28 Dec 1994
Nolan Henry Bennett
b. 19 Oct 1905 d. 2 Jan 1996
11
Deonna Ann Bennett
[1.2.1.1.3.6.6.3.1.10.1]
b. 21 May 1932 d. 22 Dec 2013
Joseph Gale Larsen
b. 13 Apr 1930 d. 16 Dec 1986
12
Jaren Larsen
[1.2.1.1.3.6.6.3.1.10.1.1]
12
Letitia Larsen
[1.2.1.1.3.6.6.3.1.10.1.2]
12
Cameron Larsen
[1.2.1.1.3.6.6.3.1.10.1.3]
12
Marcella Larsen
[1.2.1.1.3.6.6.3.1.10.1.4]
11
Boyd Nolan Bennett
[1.2.1.1.3.6.6.3.1.10.2]
b. 31 May 1936 d. 26 Jun 1985
11
Marlene Bennett
[1.2.1.1.3.6.6.3.1.10.3]
10
Maesa Ellen Bond
[1.2.1.1.3.6.6.3.1.11]
b. 21 Jan 1908 d. 2 Mar 1970
10
Edna Viola Bond
[1.2.1.1.3.6.6.3.1.12]
b. 16 Apr 1909 d. 6 Aug 2002
10
Willa Venetta Bond
[1.2.1.1.3.6.6.3.1.13]
b. 8 May 1911 d. 2 Nov 2010
10
Calvin Le Roy Bond
[1.2.1.1.3.6.6.3.1.14]
b. 25 Aug 1913 d. 30 Oct 1982
10
Hyrum Lemoine Bond
[1.2.1.1.3.6.6.3.1.15]
b. 12 Jun 1917 d. 14 Jul 2002
9
John Dame Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.3.2]
b. 23 Mar 1882 d. 14 Oct 1956
Jane Ipson Riley
b. 1 Dec 1882 d. 28 Feb 1955
10
Venice Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.3.2.1]
b. 10 Jul 1904 d. 19 Jan 1998
Karl Stott
b. 9 Feb 1901 d. 9 Jun 1991
11
Karl J Stott
[1.2.1.1.3.6.6.3.2.1.1]
b. 3 Apr 1925 d. 19 Nov 2003
Geneva Amaryllis Noland
b. 2 Oct 1928 d. 21 Jul 1988
12
Joann Kaye Stott
[1.2.1.1.3.6.6.3.2.1.1.1]
b. 10 Jul 1965 d. 18 Apr 2005 [
=>
]
12
Allen Karl Stott
[1.2.1.1.3.6.6.3.2.1.1.2]
12
Barbara Jean Stott
[1.2.1.1.3.6.6.3.2.1.1.3]
+
Karen Kay Piksa
b. 5 Aug 1940 d. 2 Sep 2006
10
Riley Edward Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.3.2.2]
b. 11 Aug 1906 d. 24 Jan 1992
+
Beulah Stewart
b. 4 Oct 1913 d. 17 May 2002
10
James Alton Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.3.2.3]
b. 19 Aug 1908 d. 15 Aug 2002
Vay Smith
b. 9 Jun 1909 d. 21 Jun 1991
11
Darlene Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.3.2.3.1]
b. 3 May 1943 d. 21 Jul 2012
10
Bryant D Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.3.2.4]
b. 13 Apr 1912 d. 21 Jun 1983
+
Dora Elizabeth Ross
b. 3 Nov 1906 d. 15 Oct 1968
10
Leland J Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.3.2.5]
b. 7 Aug 1914 d. 1 Aug 1981
Margaret Pearson
b. 16 Sep 1915 d. 30 Apr 2008
11
Bryce W Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.3.2.5.1]
b. 21 May 1940 d. 25 Apr 2008
+
Catherine
11
Jennie Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.3.2.5.2]
+
Marshall Goodrich
10
Maxine Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.3.2.6]
b. 26 Aug 1919 d. 2 May 2003
Eugene Albert Crabtree
b. 18 Sep 1910 d. 15 Jul 1998
11
Geniel Crabtree
[1.2.1.1.3.6.6.3.2.6.1]
b. 21 Mar 1947 d. 11 Sep 2011
9
Bertha Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.3.3]
b. 6 Jun 1884 d. 6 Jun 1884
9
Mary Ellen Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.3.4]
b. 6 Sep 1885 d. 26 Oct 1905
+
Leffel Pearson Croft
b. 3 Aug 1882 d. 14 Feb 1907
9
Edward Dame Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.3.5]
b. 11 Nov 1887 d. 1 Oct 1942
Myrtle Bracken
b. 9 Jun 1894 d. 2 Oct 1928
10
Clayton Douglas Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.3.5.1]
b. 27 Sep 1924 d. 29 Nov 2014
9
Rosa May Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.3.6]
b. 1 May 1890 d. 4 Dec 1975
John Harris Greer
b. 5 Apr 1886 d. 15 Feb 1939
10
Homer D Greer
[1.2.1.1.3.6.6.3.6.1]
b. 31 Oct 1909 d. 3 Jan 1924
10
Willa Ann Greer
[1.2.1.1.3.6.6.3.6.2]
b. 30 Mar 1911 d. 24 Jan 1997
+
Stanley Jay Despain
b. 3 Jan 1909 d. 25 Oct 2003
10
Kathryn Greer
[1.2.1.1.3.6.6.3.6.3]
b. 15 Dec 1913 d. 18 Jun 1998
Glen Lionel Henson
b. 8 Nov 1915 d. 18 Jul 1996
11
Kaysie Henson
[1.2.1.1.3.6.6.3.6.3.1]
b. 4 Jun 1946 d. 29 Mar 1980
10
Maxine Greer
[1.2.1.1.3.6.6.3.6.4]
b. 13 Feb 1924 d. 22 Apr 2008
10
Maurine Greer
[1.2.1.1.3.6.6.3.6.5]
b. 13 Feb 1924 d. 8 Oct 2012
9
Inez Cady Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.3.7]
b. 1 Feb 1893 d. 20 Feb 1962
Clark Allred
b. 4 Mar 1891 d. 28 Dec 1966
10
Claree Allred
[1.2.1.1.3.6.6.3.7.1]
b. 19 Oct 1913 d. 16 Oct 1950
James Sevy Judd
b. 16 Mar 1913 d. 9 Jun 2001
11
James Sevy Judd, Jr
[1.2.1.1.3.6.6.3.7.1.1]
b. 25 Oct 1933 d. 24 Jun 2003
11
Richard Clark Judd
[1.2.1.1.3.6.6.3.7.1.2]
b. 5 Aug 1936 d. 19 Jun 1957
11
Craig Allen Judd
[1.2.1.1.3.6.6.3.7.1.3]
b. 6 Feb 1950 d. 6 Feb 1950
10
Thomas Butler Allred
[1.2.1.1.3.6.6.3.7.2]
b. 12 Nov 1915 d. 10 Jun 1961
Isabell Allen
b. 30 Dec 1915 d. 13 Aug 1982
11
Sherrill Rae Allred
[1.2.1.1.3.6.6.3.7.2.1]
b. 10 Jan 1937 d. 24 Jan 1977
12
Marjie Lynn Ronnow
[1.2.1.1.3.6.6.3.7.2.1.1]
b. 29 Oct 1958 d. Jan 2006
10
Romania Jeanne Allred
[1.2.1.1.3.6.6.3.7.3]
b. 30 Apr 1921 d. 20 Feb 1983
+
Melvin Jarvis Oveson
b. 25 Nov 1919 d. 19 Aug 2008
+
Mihaly Koszta
b. 20 Mar 1933 d. 29 Jun 2000
10
Wilma Allred
[1.2.1.1.3.6.6.3.7.4]
b. 7 Dec 1922 d. 22 Jul 2001
Don B McAffee
b. 20 Jun 1920 d. Sep 2004
11
Don B McAffee, Jr
[1.2.1.1.3.6.6.3.7.4.1]
b. 28 Jul 1944 d. 8 Jan 2012
9
Birdie Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.3.8]
b. 18 Dec 1895 d. 18 Dec 1932
William Wamner Blake
b. 5 Oct 1892 d. 24 Jul 1976
10
Elva Leora Blake
[1.2.1.1.3.6.6.3.8.1]
b. 23 Sep 1916 d. 19 Jun 2011
10
Garth D Blake
[1.2.1.1.3.6.6.3.8.2]
b. 20 Sep 1918 d. 21 Apr 2004
10
Cloyd Isaac Blake
[1.2.1.1.3.6.6.3.8.3]
b. 11 Sep 1920 d. 27 Jun 1985
9
Son Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.3.9]
b. 18 Dec 1895 d. 18 Dec 1895
9
Isaac Ezra Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.3.10]
b. 12 Aug 1899 d. 26 Aug 1940
+
Viola Beckstrand
b. 27 Apr 1904 d. 19 Jul 1990
9
Callmore Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.3.11]
b. 6 Jan 1901 d. 5 Dec 1905
9
Norman Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.3.12]
b. 2 Nov 1904 d. 20 Jul 1955
+
Della Grace Lindblade
b. 25 Jul 1907 d. 6 Aug 1970
8
Daniel Brockbank Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.4]
b. 22 Jun 1862 d. 7 Dec 1940
Susan Dearden
b. 22 Dec 1869 d. 22 Oct 1943
9
Charlotte Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.4.1]
b. 1 Dec 1888 d. 19 Oct 1965
Joseph Ezra Dame
b. 28 Jan 1887 d. 22 May 1971
10
Alton Fay Dame
[1.2.1.1.3.6.6.4.1.1]
b. 24 Dec 1912 d. 31 Mar 1968
Bernice Margaret Hansen
b. 9 Jan 1918 d. 31 Mar 1968
11
Linda Joy Dame
[1.2.1.1.3.6.6.4.1.1.1]
b. 6 Oct 1940 d. 2 Mar 2013
10
Helen Dame
[1.2.1.1.3.6.6.4.1.2]
b. 28 Jul 1914 d. 2 Apr 2001
+
Lamont Martin Jensen
b. 31 Oct 1914 d. 29 Mar 2010
10
Ezra Orren Dame
[1.2.1.1.3.6.6.4.1.3]
b. 14 Jul 1916 d. 17 Mar 1985
10
Roland Stott Dame
[1.2.1.1.3.6.6.4.1.4]
b. 15 Jan 1920 d. 12 Jul 2003
Ruth Huffaker
b. 24 May 1924 d. 28 Nov 2019
11
Bruce Dame
[1.2.1.1.3.6.6.4.1.4.1]
+
Susan
11
Dennis Dame
[1.2.1.1.3.6.6.4.1.4.2]
11
Janice Dame
[1.2.1.1.3.6.6.4.1.4.3]
11
Carol Dame
[1.2.1.1.3.6.6.4.1.4.4]
+
Garn Brown
11
Marilyn Dame
[1.2.1.1.3.6.6.4.1.4.5]
+
Clint Bendtsen
10
Ellen Mae Dame
[1.2.1.1.3.6.6.4.1.5]
b. 14 Apr 1921 d. 4 Jul 2009
+
Vernon Orgill Jones
b. 5 Feb 1920 d. 3 May 2000
10
Evelyn Dame
[1.2.1.1.3.6.6.4.1.6]
b. 28 Sep 1925 d. 20 Jan 2008
+
Jack Monrad Reed
b. 6 Jun 1920 d. 27 Nov 1993
10
Verla Dame
[1.2.1.1.3.6.6.4.1.7]
b. 17 Jan 1934 d. 16 Jul 2005
+
Pedersen
9
Agnes Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.4.2]
b. 23 Jan 1890 d. 25 Feb 1940
Henry Robison
b. 16 Jan 1888 d. 3 Jul 1951
10
Lincoln Henry Robison
[1.2.1.1.3.6.6.4.2.1]
b. 19 Feb 1911 d. 19 Feb 1911
10
Marvin B Robison
[1.2.1.1.3.6.6.4.2.2]
b. 26 Jan 1914 d. 11 Mar 2004
+
Susanna Spackman
b. 19 Feb 1915 d. 30 Sep 2009
10
Ora Robison
[1.2.1.1.3.6.6.4.2.3]
b. 17 Jul 1915 d. 12 Dec 2010
Wilmer Stoker Barlow
b. 12 Nov 1909 d. 25 Dec 1981
11
Wilmer Stoker Barlow, Jr
[1.2.1.1.3.6.6.4.2.3.1]
b. 22 Mar 1942 d. 12 Jul 1942
10
Rosa Robison
[1.2.1.1.3.6.6.4.2.4]
b. 19 Oct 1916 d. 25 Sep 1951
+
Wilford August Pearson
b. 1 Jun 1914 d. 8 Jan 1993
10
Clark Virgil Robison
[1.2.1.1.3.6.6.4.2.5]
b. 30 Aug 1918 d. 26 Feb 1990
9
Daughter Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.4.3]
b. 28 Aug 1891 d. 28 Aug 1891
9
Daniel Dearden Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.4.4]
b. 18 Dec 1892 d. 1 Oct 1980
Melba Ellen Stott
b. 2 Sep 1898 d. 15 Jan 1987
10
Joseph Merrill Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.4.4.1]
b. 19 Jun 1920 d. 18 Sep 2009
Lillian Lucille Booth
b. 5 Jun 1925 d. 25 Apr 1997
11
Bruce Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.4.4.1.1]
+
Karie
11
Ned Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.4.4.1.2]
+
Marianne
11
Pamela Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.4.4.1.3]
+
David Price
11
Annette Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.4.4.1.4]
+
Ron Perry
+
Ann Aldous Halgren
b. 2 Oct 1925 d. 21 Jan 2020
10
Daniel Stott Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.4.4.2]
b. 15 Nov 1923 d. 23 Dec 2002
+
Audrey Huffaker
b. 18 Feb 1924 d. 12 Nov 1962
10
Fred Jewel Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.4.4.3]
b. 4 Aug 1928 d. 8 Oct 2016
10
Ted Darrell Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.4.4.4]
b. 7 Mar 1934 d. 6 Apr 2017
9
Flora Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.4.5]
b. 10 Sep 1894 d. 3 Nov 1978
Charles Orval Stott
b. 14 May 1894 d. 24 Oct 1964
10
Verna Stott
[1.2.1.1.3.6.6.4.5.1]
b. 12 Aug 1917 d. 3 Jul 1974
+
William Kenneth Bach
b. 25 Mar 1911 d. 5 Feb 2008
10
Merlene Stott
[1.2.1.1.3.6.6.4.5.2]
b. 24 Mar 1919 d. 26 Mar 2008
Loyal Bain Cook
b. 20 Aug 1918 d. 4 Jan 1963
11
Kent Loyal Cook
[1.2.1.1.3.6.6.4.5.2.1]
b. 18 Oct 1956 d. 22 Sep 2002
+
Deena
11
Stott Cook
[1.2.1.1.3.6.6.4.5.2.2]
11
Connie Cook
[1.2.1.1.3.6.6.4.5.2.3]
+
Charles Hulme
11
Bonieta Cook
[1.2.1.1.3.6.6.4.5.2.4]
+
Devon Deppe
11
Dwight Cook
[1.2.1.1.3.6.6.4.5.2.5]
+
Barbara
11
Carla Cook
[1.2.1.1.3.6.6.4.5.2.6]
+
Ken Cox
10
Flora Ruth Stott
[1.2.1.1.3.6.6.4.5.3]
b. 11 Jul 1925 d. 5 Jul 2011
+
Ralph Taylor Silver
b. 22 Dec 1923 d. 27 Aug 2013
9
Albert Irving Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.4.6]
b. 22 Mar 1896 d. 29 Dec 1907
9
Howard Owen Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.4.7]
b. 31 Dec 1898 d. 21 Apr 1900
9
Dell LeRoy Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.4.8]
b. 28 Aug 1900 d. 10 Feb 1921
9
Clara Isabella Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.4.9]
b. 3 Jan 1902 d. Aug 1902
9
Bertha Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.4.10]
b. 6 Jul 1903 d. 31 Mar 1946
Mark Stephenson
b. 6 Dec 1902 d. 28 Nov 1958
10
Veleta Stephenson
[1.2.1.1.3.6.6.4.10.1]
b. 7 Sep 1925 d. 29 Dec 1987
Owen G Kerr
b. 15 Feb 1921 d. 18 Feb 1982
11
Stephen W. Kerr
[1.2.1.1.3.6.6.4.10.1.1]
10
Margene Stephenson
[1.2.1.1.3.6.6.4.10.2]
b. 26 Jan 1929 d. 13 May 2000
10
Gloria Mae Stephenson
[1.2.1.1.3.6.6.4.10.3]
b. 1 Jan 1936 d. 11 Apr 2020
9
Alonzo Davies Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.4.11]
b. 18 Nov 1905 d. 20 Aug 1973
Dorothy Josephine Cox
b. 17 Sep 1905 d. 23 Mar 1995
10
Boneta Josephine Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.4.11.1]
b. 1 Jun 1928 d. 16 Jan 2019
Lewis Keith Williams
b. 9 Jul 1926 d. 9 Apr 1991
11
Keith Roger Williams
[1.2.1.1.3.6.6.4.11.1.1]
b. 10 Sep 1951 d. 19 May 2017
10
Donna Dean Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.4.11.2]
b. 28 Mar 1930 d. 4 Apr 1998
9
Leland Mainwaring Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.4.12]
b. 23 Apr 1908 d. 9 Jul 1972
Lola Duncan
b. 11 Apr 1915 d. 25 Jan 2006
10
Elmer Leon Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.4.12.1]
b. 8 Mar 1935 d. 7 Aug 2000
Living
11
Living
[1.2.1.1.3.6.6.4.12.1.1]
11
Living
[1.2.1.1.3.6.6.4.12.1.2]
10
Dixie Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.4.12.2]
b. 22 Nov 1940 d. 22 Jul 2018
Leslie Dee Allred
b. 11 Oct 1935 d. 12 May 1998
11
Living
[1.2.1.1.3.6.6.4.12.2.1]
11
Living
[1.2.1.1.3.6.6.4.12.2.2]
11
Living
[1.2.1.1.3.6.6.4.12.2.3]
11
Living
[1.2.1.1.3.6.6.4.12.2.4]
10
Jim L Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.4.12.3]
b. 7 Apr 1946 d. 21 Mar 1994
Living
11
Living
[1.2.1.1.3.6.6.4.12.3.1]
11
Living
[1.2.1.1.3.6.6.4.12.3.2]
11
Living
[1.2.1.1.3.6.6.4.12.3.3]
11
Living
[1.2.1.1.3.6.6.4.12.3.4]
11
Living
[1.2.1.1.3.6.6.4.12.3.5]
9
Alice Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.4.13]
b. 27 Jan 1910 d. 14 Sep 2003
Blake Stephenson
b. 15 Jun 1909 d. 2 Apr 1988
10
LoReta Stephenson
[1.2.1.1.3.6.6.4.13.1]
b. 18 Aug 1935 d. 23 Aug 2017
10
Kay Stephenson
[1.2.1.1.3.6.6.4.13.2]
b. 1 Feb 1940 d. 11 Jul 1941
9
Evert Stanley Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.4.14]
b. 27 Jun 1913 d. 27 Oct 1991
Ruby Flora Day
b. 1 May 1915 d. 18 Jan 1995
10
Stanley Wardell Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.4.14.1]
b. 29 Oct 1935 d. 19 Aug 2017
10
Living
[1.2.1.1.3.6.6.4.14.2]
10
Val Dean Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.4.14.3]
b. 2 Oct 1954 d. 2 Jan 1956
8
Howard Brockbank Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.5]
b. 12 Jan 1865 d. 28 Nov 1947
Mary Elizabeth Labrum
b. 3 Jan 1868 d. 3 Feb 1947
9
Adrian Howard Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.5.1]
b. 13 Nov 1887 d. 19 Nov 1887
9
Lula Jane Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.5.2]
b. 21 Jan 1889 d. 23 Jan 1971
Karl Emil Pearson
b. 11 Oct 1884 d. 28 Dec 1970
10
Van Dale Pearson
[1.2.1.1.3.6.6.5.2.1]
b. 15 Aug 1908 d. 9 Nov 1990
+
Norma Jean Chesley
b. 23 Oct 1909 d. 14 Sep 1992
10
Anona Joy Pearson
[1.2.1.1.3.6.6.5.2.2]
b. 22 Feb 1910 d. 8 Mar 2002
+
Francis B Chesley
b. 19 Apr 1908 d. 29 Nov 1990
10
Karl Elmo Stanley Pearson
[1.2.1.1.3.6.6.5.2.3]
b. 6 Nov 1912 d. 24 Jan 1994
Ila Bennett
b. 3 Apr 1912 d. 25 Jun 2006
11
Ila Larayne Pearson
[1.2.1.1.3.6.6.5.2.3.1]
b. 18 Mar 1933 d. 16 Dec 2008
11
Kayle Ruth Pearson
[1.2.1.1.3.6.6.5.2.3.2]
11
Rochelle Pearson
[1.2.1.1.3.6.6.5.2.3.3]
11
Rex Stanley Pearson
[1.2.1.1.3.6.6.5.2.3.4]
10
Daryl Howard Pearson
[1.2.1.1.3.6.6.5.2.4]
b. 14 Jan 1919 d. 2 Sep 2006
+
Ivy Roberts
b. 12 Feb 1918 d. 18 Feb 1992
10
LuJuana Mae Pearson
[1.2.1.1.3.6.6.5.2.5]
b. 21 Oct 1930 d. 7 Nov 2015
+
Joseph Loraine Smith
b. 10 Sep 1929 d. 17 Aug 2017
9
Orin Labrum Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.5.3]
b. 25 Nov 1890 d. 29 Nov 1890
9
George Labrum Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.5.4]
b. 12 Jun 1892 d. 29 Dec 1962
Iva Bell Swallow
b. 6 Aug 1894 d. 1 Oct 1964
10
Mildred Hope Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.5.4.1]
b. 22 Apr 1916 d. 20 Jun 1999
Glendon Clark Porter
b. 23 Jun 1909 d. 16 Jul 1993
11
Hal G Porter
[1.2.1.1.3.6.6.5.4.1.1]
b. 2 Jun 1939 d. 27 Feb 1975
Emma Jean Duke
b. 24 Jul 1944 d. 30 Sep 1997
12
Cindi Jean Porter
[1.2.1.1.3.6.6.5.4.1.1.1]
b. 11 Nov 1968 d. 5 Jan 2006
10
Howard Elmo Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.5.4.2]
b. 8 Jul 1918 d. 24 Dec 1983
Iris Smith
b. 11 Apr 1920 d. 1 Oct 2010
11
Koye Mabel Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.5.4.2.1]
b. 21 Jul 1940 d. 25 Mar 1977
Living
12
Quinton Harvey Mecham
[1.2.1.1.3.6.6.5.4.2.1.1]
b. 7 Oct 1962 d. 13 Dec 1999
10
Faryl George Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.5.4.3]
b. 13 Aug 1921 d. 3 Apr 1960
Joyce Johnson
b. 23 Dec 1920 d. 25 Dec 2005
11
Dwight J Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.5.4.3.1]
b. 17 Sep 1944 d. 22 Sep 1999
+
Bobette
11
Pat Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.5.4.3.2]
+
Haynes R Fuller
11
Bonnie Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.5.4.3.3]
+
James H Quigley
10
Joy Elaine Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.5.4.4]
b. 13 Feb 1923 d. 13 Jun 2016
+
John Clifford Ashman
b. 24 May 1918 d. 17 Feb 1970
+
Robert Earl Harper
b. 12 Oct 1918 d. 19 Aug 2004
10
Dean C Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.5.4.5]
b. 17 Aug 1924 d. 16 Sep 2004
+
Stella Louise Haise
b. 9 Jul 1912 d. 16 May 2001
10
George Labrum Bushnell, Jr
[1.2.1.1.3.6.6.5.4.6]
b. 8 Feb 1928 d. 19 Dec 2005
Melba Arlene Arave
b. 25 Nov 1930 d. 26 Dec 1973
11
Daniel J Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.5.4.6.1]
b. 11 Jul 1948 d. 25 Nov 2010
11
Krystina Boyle
[1.2.1.1.3.6.6.5.4.6.2]
b. 11 Feb 1951 d. 20 Apr 2021
11
Son Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.5.4.6.3]
b. 7 Jun 1954 d. 7 Jun 1954
Marilyn Clark
b. 26 Feb 1932 d. 21 Apr 1990
11
Paula Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.5.4.6.4]
+
Rafael Rivera
11
Nancy Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.5.4.6.5]
+
K C Ericksen
11
Stephen Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.5.4.6.6]
+
Sherry
11
Jana Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.5.4.6.7]
+
E H Van Bree
+
Benita Ann Schwartz
b. 19 Oct 1933 d. 16 Apr 2016
10
Howard Charles Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.5.4.7]
b. 30 Oct 1939 d. 31 Oct 1939
10
Van Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.5.4.8]
+
Alison
9
Mabel Alice Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.5.5]
b. 15 May 1900 d. 2 Jun 1924
+
James Clyde Fisher
b. 5 Jun 1896 d. 19 Nov 1977
8
Joshua Brockbank Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.6]
b. 25 Feb 1867 d. 22 Dec 1943
Ann Dearden
b. 8 Oct 1877 d. 31 Oct 1951
9
Grace Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.6.1]
b. 7 Nov 1898 d. 26 May 1963
Sherman Cooper
b. 29 Oct 1887 d. 1 Jul 1965
10
Grant Sherman Cooper
[1.2.1.1.3.6.6.6.1.1]
b. 30 Mar 1923 d. 6 May 2006
+
Ruby Schow
b. 19 May 1929 d. 31 Jan 2000
10
Zola Elizabeth Cooper
[1.2.1.1.3.6.6.6.1.2]
b. 1 Nov 1925 d. 27 Nov 2004
Joseph Vane Barker
b. 4 Aug 1917 d. 18 Feb 2005
11
Elizabeth Barker
[1.2.1.1.3.6.6.6.1.2.1]
b. 18 Jun 1958 d. 19 Jun 1958
10
Jay Elijah Cooper
[1.2.1.1.3.6.6.6.1.3]
b. 5 Oct 1930 d. 1 Aug 2016
10
Romney Bushnell Cooper
[1.2.1.1.3.6.6.6.1.4]
b. 27 Jan 1933 d. 19 Feb 1933
9
Nolan Joshua Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.6.2]
b. 6 Jun 1901 d. 19 Feb 1951
Hattie Gertrude Webb
b. 30 Sep 1899 d. 24 Jan 1974
10
Lorraine Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.6.2.1]
b. 6 Sep 1929 d. 9 Dec 1996
+
Robert Frank Mackness
b. 19 Dec 1921 d. 15 Jul 2000
10
Shirley Jean Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.6.2.2]
b. 29 Dec 1932 d. 26 Sep 1987
Dale Charles Jensen
b. 4 Jul 1923 d. 7 Mar 1978
11
Paul Bushnell Jensen
[1.2.1.1.3.6.6.6.2.2.1]
b. 7 Apr 1956 d. 19 Nov 2008
10
Harold Nolan Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.6.2.3]
b. 11 Aug 1934 d. 14 Jun 1936
10
Kenneth J Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.6.2.4]
b. 22 Nov 1938 d. 22 Nov 1938
10
Donald Webb Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.6.2.5]
b. 17 Nov 1940 d. 30 Sep 2007
9
Clarence Henry Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.6.3]
b. 4 Jul 1906 d. 14 Aug 1958
Delma Nelson
b. 14 Nov 1912 d. 14 Feb 1994
10
Marilyn Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.6.3.1]
b. 21 Nov 1938 d. 8 Aug 2017
9
Florence Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.6.4]
b. 1 Aug 1908 d. 31 Mar 1987
Merrill Nels Anderson
b. 7 Jul 1912 d. 15 Mar 1990
10
Barbara Rae Anderson
[1.2.1.1.3.6.6.6.4.1]
b. 10 Jul 1937 d. 15 Jan 2018
9
Floyd Davies Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.6.5]
b. 13 Jan 1911 d. 10 Mar 1911
9
Sarah Zola Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.6.6]
b. 1 Dec 1913 d. 6 Nov 1919
9
Ann Oleen Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.6.7]
b. 1 Nov 1917 d. 24 Oct 1978
Francis Carl Bach
b. 15 Aug 1911 d. 16 Oct 1954
10
Michel Sebastian Bach
[1.2.1.1.3.6.6.6.7.1]
b. 6 Jun 1941 d. 29 Nov 1963
+
Mike Carl Gessner
b. 15 May 1903 d. 29 Sep 1980
9
Reed Thomas Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.6.8]
b. 12 Mar 1922 d. 12 Aug 1990
Jeanne Christensen
b. 1 Nov 1920 d. 30 Apr 2015
10
Gail Keith Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.6.8.1]
b. 24 Jul 1947 d. 27 Nov 1986
8
Elizabeth Brockbank Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.7]
b. 11 Apr 1869 d. 26 Jun 1934
William Hyrum Bennett
b. 27 Oct 1869 d. 24 Apr 1947
9
Noble William Bennett
[1.2.1.1.3.6.6.7.1]
b. 27 Aug 1895 d. 10 Sep 1895
9
Sterling John Bennett
[1.2.1.1.3.6.6.7.2]
b. 1 Aug 1896 d. 17 Dec 1978
Amanda Marie Gleason
b. 20 Jan 1905 d. 13 Jul 1997
10
Beth Marie Bennett
[1.2.1.1.3.6.6.7.2.1]
b. 23 Aug 1925 d. 14 Dec 2001
+
Robert Kent Willardson
b. 11 Jul 1923 d. 17 Jan 2007
10
Sterling John Bennett, Jr
[1.2.1.1.3.6.6.7.2.2]
b. 10 Aug 1928 d. 15 Jul 2012
+
Marilyn Jensen
9
Howard Joshua Bennett
[1.2.1.1.3.6.6.7.3]
b. 24 Jul 1898 d. 13 Apr 1977
Violet Stewart
b. 2 Jan 1898 d. 29 Mar 1967
10
William Stewart Bennett
[1.2.1.1.3.6.6.7.3.1]
b. 30 Mar 1921 d. 28 Sep 1978
+
Lila Lee Steffensen
b. 9 Dec 1924 d. 7 Aug 2006
10
June Bennett
[1.2.1.1.3.6.6.7.3.2]
b. 27 Jun 1923 d. 17 Dec 1993
Francis Glade Johnson
b. 28 Aug 1923 d. 28 Aug 2005
11
Lyle G Johnson
[1.2.1.1.3.6.6.7.3.2.1]
11
Roy B Johnson
[1.2.1.1.3.6.6.7.3.2.2]
b. 8 Feb 1952 d. 21 Oct 2011
Patsey Robison
12
Katie Johnson
[1.2.1.1.3.6.6.7.3.2.2.1]
[
=>
]
12
Nate Johnson
[1.2.1.1.3.6.6.7.3.2.2.2]
[
=>
]
12
Heather Johnson
[1.2.1.1.3.6.6.7.3.2.2.3]
11
Raymond J Johnson
[1.2.1.1.3.6.6.7.3.2.3]
b. 8 Feb 1952 d. 9 Feb 1952
10
Joy Bennett
[1.2.1.1.3.6.6.7.3.3]
b. 27 Jun 1923 d. 9 Jan 2009
+
Harold Greenwood
b. 13 Apr 1919 d. 24 Apr 1991
10
Jay Howard Bennett
[1.2.1.1.3.6.6.7.3.4]
b. 26 Jun 1926 d. 21 May 1945
9
Geneva Bennett
[1.2.1.1.3.6.6.7.4]
b. 16 Aug 1901 d. 17 Apr 1984
Willis Eugene Black
b. 9 Nov 1896 d. 16 Nov 1983
10
Willis Eugene Black, Jr
[1.2.1.1.3.6.6.7.4.1]
b. 1 May 1925 d. 14 Nov 1975
+
Mabel Elizabeth Hillier
b. 21 Oct 1925 d. 17 Sep 1978
10
Deaun Black
[1.2.1.1.3.6.6.7.4.2]
b. 11 Sep 1926 d. 23 Feb 2013
Harold Ashby Anderson
b. 24 Oct 1924 d. 23 Sep 2014
11
Brooks Anderson
[1.2.1.1.3.6.6.7.4.2.1]
b. 16 Dec 1950 d. 16 Dec 1950
10
Beth Luane Black
[1.2.1.1.3.6.6.7.4.3]
b. 29 Dec 1927 d. 1 Nov 2019
Bertis Elroy Frampton
b. 24 Feb 1924 d. 21 Jan 2000
11
Susan Frampton
[1.2.1.1.3.6.6.7.4.3.1]
b. 24 Jul 1952 d. 16 Jul 2020
10
Birdie Carol Black
[1.2.1.1.3.6.6.7.4.4]
b. 17 Feb 1930 d. 2 Sep 2014
+
Vervin Vernile Bradshaw
b. 23 Aug 1922 d. 9 Jul 2000
Earl J Frampton
b. 22 Mar 1930 d. 26 May 2007
11
Mark Earl Frampton
[1.2.1.1.3.6.6.7.4.4.1]
b. 3 Jun 1958 d. 31 May 1977
10
Edna Gwen Black
[1.2.1.1.3.6.6.7.4.5]
b. 17 Sep 1932 d. 19 Sep 2019
Mitchell LaMar Hodges
b. 12 May 1931 d. 18 May 2005
11
Gwendolyn Hodges
[1.2.1.1.3.6.6.7.4.5.1]
+
Jerry Averett
11
Connie Hodges
[1.2.1.1.3.6.6.7.4.5.2]
+
Craig Teeples
11
Tamra Hodges
[1.2.1.1.3.6.6.7.4.5.3]
+
Ted Peterson
11
Michael Hodges
[1.2.1.1.3.6.6.7.4.5.4]
+
Carma
11
Nancy Hodges
[1.2.1.1.3.6.6.7.4.5.5]
+
Jamie Orton
10
Joyce Black
[1.2.1.1.3.6.6.7.4.6]
b. 3 Jan 1936 d. 11 Sep 1991
+
Dix LeRoy Monroe
b. 18 Sep 1934 d. 17 Jun 2007
10
Bennett Warren Black
[1.2.1.1.3.6.6.7.4.7]
b. 31 Jan 1941 d. 14 Nov 1975
+
Living
9
Arvilla Bennett
[1.2.1.1.3.6.6.7.5]
b. 20 Oct 1903 d. 29 Dec 1979
Rodney Anthony Ashby
b. 20 Jan 1905 d. 7 Oct 1971
10
Gordon Bennett Ashby
[1.2.1.1.3.6.6.7.5.1]
b. 22 May 1928 d. 22 Jun 1928
10
Kay Bennett Ashby
[1.2.1.1.3.6.6.7.5.2]
b. 25 Sep 1929 d. 5 Nov 2014
+
Mary Joan White
b. 20 Apr 1930 d. 14 Nov 2016
10
Garth Rodney Ashby
[1.2.1.1.3.6.6.7.5.3]
b. 5 Jan 1931 d. 6 Dec 2017
+
Joyce Katherine Sunberg
10
Gloria Ashby
[1.2.1.1.3.6.6.7.5.4]
b. 5 Jan 1931 d. 3 Jan 2006
+
Wallace George Rupp
b. 17 Sep 1928 d. 25 Sep 2016
10
Renon Ashby
[1.2.1.1.3.6.6.7.5.5]
b. 23 Aug 1932 d. 19 May 2003
+
Richard Ernest Cartwright
10
Malan Bennett Ashby
[1.2.1.1.3.6.6.7.5.6]
b. 25 Sep 1934 d. 15 Jan 2004
+
Gladys Hall
10
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.5.7]
+
Kathleen Cutler
9
Leona Bennett
[1.2.1.1.3.6.6.7.6]
b. 11 Oct 1905 d. 25 Aug 1997
Nephi Besendorfer
b. 1 Aug 1904 d. 24 Aug 1944
10
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.6.1]
James Neale Jensen
b. 27 Jul 1923 d. 9 Apr 2013
11
James Neale Jensen
[1.2.1.1.3.6.6.7.6.1.1]
+
Ada
11
Diana Jensen
[1.2.1.1.3.6.6.7.6.1.2]
+
Marte Green
11
Patty Jensen
[1.2.1.1.3.6.6.7.6.1.3]
+
Vaughn Hutchinson
11
Susan Jensen
[1.2.1.1.3.6.6.7.6.1.4]
10
Son Besendorfer
[1.2.1.1.3.6.6.7.6.2]
b. Aug 1931 d. 1931
10
Daughter Besendorfer
[1.2.1.1.3.6.6.7.6.3]
b. Mar 1932 d. 1932
10
William Nephi Besendorfer
[1.2.1.1.3.6.6.7.6.4]
b. 23 Oct 1933 d. 29 Apr 1987
+
Donna Casper
+
Dora Leila Jensen
b. 24 Aug 1932 d. 9 May 2012
10
Maradene Besendorfer
[1.2.1.1.3.6.6.7.6.5]
b. 26 Jun 1939 d. 3 Oct 2020
+
Donald Alden Heap
10
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.6.6]
+
Sydney Kay Larsen
9
Vaun Mainwaring Bennett
[1.2.1.1.3.6.6.7.7]
b. 29 Mar 1911 d. 5 Apr 2004
Phyllis Lyle Talbot
b. 4 Jul 1912 d. 5 Oct 2000
10
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.7.1]
+
Thora Annette Petersen
10
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.7.2]
+
Natalie Jean Hale
10
Phil Talbot Bennett
[1.2.1.1.3.6.6.7.7.3]
b. 24 Mar 1939 d. 28 Sep 2001
+
Marilyn Mae Allred
10
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.7.4]
+
Beverly Jane Bell
10
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.7.5]
+
Rex C Day
9
Edna Bennett
[1.2.1.1.3.6.6.7.8]
b. 27 Aug 1913 d. 26 Oct 1995
Floyd E Duncan
b. 23 Oct 1911 d. 4 Oct 1994
10
Floris Duncan
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.1]
b. 14 May 1938 d. 29 Nov 2019
Alton Bertine Haile, Jr
b. 14 May 1938 d. 24 May 2009
11
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.1.1]
12
Anthony Haile
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.1.1.1]
11
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.1.2]
Porfie Martinez
12
Maylene Edna Martinez
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.1.2.1]
12
Porfie Floyd Martinez
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.1.2.2]
12
Esperanza Diane Martinez
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.1.2.3]
10
Dayle Duncan
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.2]
b. 27 Jun 1940 d. 24 Dec 2020
Tommy Bruce King
b. 3 Jan 1940 d. 10 Dec 1974
11
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.2.1]
Living
12
Richard Nelson Whipple
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.2.1.1]
b. 17 Feb 1981 d. 17 Feb 1981
12
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.2.1.2]
[
=>
]
12
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.2.1.3]
[
=>
]
12
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.2.1.4]
[
=>
]
12
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.2.1.5]
12
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.2.1.6]
12
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.2.1.7]
Living
11
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.2.2]
+
Leslie DeAnn Dayton
b. 19 Oct 1952 d. 10 Oct 2020
11
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.2.3]
Living
12
Richard Nelson Whipple
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.2.3.1]
b. 17 Feb 1981 d. 17 Feb 1981
12
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.2.3.2]
[
=>
]
12
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.2.3.3]
[
=>
]
12
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.2.3.4]
[
=>
]
12
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.2.3.5]
12
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.2.3.6]
12
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.2.3.7]
11
Warren Montgomery White
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.2.4]
b. 13 Aug 1963 d. 8 Feb 2010
Living
12
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.2.4.1]
[
=>
]
11
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.2.5]
Living
12
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.2.5.1]
12
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.2.5.2]
12
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.2.5.3]
12
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.2.5.4]
11
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.2.6]
Living
12
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.2.6.1]
12
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.2.6.2]
12
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.2.6.3]
12
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.2.6.4]
10
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.3]
Gary Lee Talbot
b. 2 Jan 1939 d. 20 Oct 2007
11
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.3.1]
Living
12
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.3.1.1]
12
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.3.1.2]
12
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.3.1.3]
Living
11
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.3.2]
Living
12
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.3.2.1]
12
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.3.2.2]
12
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.3.2.3]
11
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.3.3]
Living
12
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.3.3.1]
12
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.3.3.2]
11
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.3.4]
+
Tamra Callahan
11
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.3.5]
Living
12
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.3.5.1]
11
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.3.6]
+
Jerrod Cornia
11
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.3.7]
11
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.3.8]
+
Scott Nathan Jensen
10
Edna Ruth Duncan
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.4]
b. 29 May 1948 d. 27 May 2023
Living
11
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.4.1]
11
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.4.2]
11
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.4.3]
+
Living
11
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.4.4]
Living
12
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.4.4.1]
12
Austen Kelly Sartori
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.4.4.2]
b. 20 Aug 1996 d. 30 Aug 1996
12
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.4.4.3]
11
Living
[1.2.1.1.3.6.6.7.8.4.5]
8
Eliza Jane Bushnell
[1.2.1.1.3.6.6.8]
b. 25 Dec 1871 d. 26 Mar 1958
Alison Algar Stott
b. 30 Aug 1864 d. 11 Dec 1952
9
Jesse Stott
[1.2.1.1.3.6.6.8.1]
b. 16 Jan 1890 d. 16 May 1961
Ploma Marie Whitaker
b. 10 Jul 1900 d. 25 Jun 1979
10
Jesse Lowell Stott
[1.2.1.1.3.6.6.8.1.1]
b. 11 Aug 1918 d. 20 May 1937
10
Douglas Whitaker Stott
[1.2.1.1.3.6.6.8.1.2]
b. 2 Sep 1925 d. 23 Feb 2013
9
Allison Stott
[1.2.1.1.3.6.6.8.2]
b. 24 Feb 1892 d. 13 Mar 1961
Ethelyn Warner
b. 1 Jul 1897 d. 24 Jul 1971
10
Allison Darrell Stott
[1.2.1.1.3.6.6.8.2.1]
b. 26 Mar 1918 d. 16 Nov 1998
Portia Olene Whicker
b. 8 Jun 1916 d. 31 Dec 1996
11
Allison Chad Stott
[1.2.1.1.3.6.6.8.2.1.1]
b. 7 Dec 1938 d. 16 Sep 2011
11
Colin Darrell Stott
[1.2.1.1.3.6.6.8.2.1.2]
b. 21 Sep 1945 d. 28 Sep 1992
10
Bettie Doris Stott
[1.2.1.1.3.6.6.8.2.2]
b. 5 Oct 1923 d. 23 Apr 1932
10
Patsy Kay Stott
[1.2.1.1.3.6.6.8.2.3]
b. 22 Jun 1937 d. 25 Jun 1937
9
Isaac Bushnell Stott
[1.2.1.1.3.6.6.8.3]
b. 6 Apr 1894 d. 10 Feb 1969
Elvira Ann Lance
b. 4 May 1892 d. 3 Dec 1966
10
Alger Lance Stott
[1.2.1.1.3.6.6.8.3.1]
b. 19 Jul 1915 d. 12 Mar 1923
10
Errol J Stott
[1.2.1.1.3.6.6.8.3.2]
b. 2 Nov 1916 d. 21 Oct 2002
10
Don Lance Stott
[1.2.1.1.3.6.6.8.3.3]
b. 5 May 1920 d. 7 Jan 1978
10
Max Lance Stott
[1.2.1.1.3.6.6.8.3.4]
b. 22 Mar 1925 d. 27 Sep 1992
9
Leonard Stott
[1.2.1.1.3.6.6.8.4]
b. 12 Jun 1896 d. 12 Jun 1977
Leone Hannah Adams
b. 8 Feb 1905 d. 30 Jun 1984
10
Eldon Adams Stott
[1.2.1.1.3.6.6.8.4.1]
b. 1 Jun 1925 d. 5 Oct 1991
10
Dean Alan Stott
[1.2.1.1.3.6.6.8.4.2]
b. 18 Oct 1928 d. 26 Nov 1942
10
Living
[1.2.1.1.3.6.6.8.4.3]
9
Howard Stott
[1.2.1.1.3.6.6.8.5]
b. 3 Aug 1898 d. 10 Jul 1982
Edith Grace George
b. 22 Jul 1901 d. 26 Mar 1980
10
Edith Stott
[1.2.1.1.3.6.6.8.5.1]
b. 11 Mar 1919 d. 2 Feb 2003
+
Boyd Beauregard Dearden
b. 4 Dec 1914 d. 10 Aug 1994
10
Gerald Howard Stott
[1.2.1.1.3.6.6.8.5.2]
b. 7 Mar 1924 d. 20 Jan 2008
10
George Howard Stott
[1.2.1.1.3.6.6.8.5.3]
b. 13 Apr 1929 d. 20 Sep 1988
+
Diane Thompson
b. 25 Feb 1933 d. 21 Nov 2010
10
Madeleine Gail Stott
[1.2.1.1.3.6.6.8.5.4]
b. 20 Apr 1937 d. 1 Jun 2014
10
Stephen Larry Stott
[1.2.1.1.3.6.6.8.5.5]
b. 4 Sep 1939 d. 5 Jun 2008
9
Karl Stott
[1.2.1.1.3.6.6.8.6]
b. 9 Feb 1901 d. 9 Jun 1991
Venice Bushnell
b. 10 Jul 1904 d. 19 Jan 1998
10
Karl J Stott
[1.2.1.1.3.6.6.8.6.1]
b. 3 Apr 1925 d. 19 Nov 2003
Geneva Amaryllis Noland
b. 2 Oct 1928 d. 21 Jul 1988
11
Joann Kaye Stott
[1.2.1.1.3.6.6.8.6.1.1]
b. 10 Jul 1965 d. 18 Apr 2005
Vernon Lee Crandall
12
Garion Crandall
[1.2.1.1.3.6.6.8.6.1.1.1]
12
Braden Crandall
[1.2.1.1.3.6.6.8.6.1.1.2]
12
Noland Crandall
[1.2.1.1.3.6.6.8.6.1.1.3]
11
Allen Karl Stott
[1.2.1.1.3.6.6.8.6.1.2]
+
Dianna
11
Barbara Jean Stott
[1.2.1.1.3.6.6.8.6.1.3]
+
Karen Kay Piksa
b. 5 Aug 1940 d. 2 Sep 2006
9
Willis Stott
[1.2.1.1.3.6.6.8.7]
b. 15 Aug 1903 d. 22 Mar 1957
Ida Fredericka Hansen
b. 26 Jan 1910 d. 30 Oct 1979
10
Norita Marie Stott
[1.2.1.1.3.6.6.8.7.1]
b. 4 Mar 1933 d. 28 Aug 1991
10
Willis La Voy Stott
[1.2.1.1.3.6.6.8.7.2]
b. 21 Sep 1939 d. 21 Mar 2003
9
Blaine Stott
[1.2.1.1.3.6.6.8.8]
b. 12 Oct 1905 d. 21 May 1978
+
Pheby Melvina Holt
b. 26 Aug 1907 d. 8 Feb 2004
9
Sarah Eva Stott
[1.2.1.1.3.6.6.8.9]
b. 27 Aug 1907 d. 1 Dec 1987
Ancil Platte Robison
b. 11 Apr 1903 d. 3 Jul 1962
10
Eva Luana Robison
[1.2.1.1.3.6.6.8.9.1]
b. 9 Jul 1929 d. 20 Jan 2015
10
Alonzo Thorpe Robison
[1.2.1.1.3.6.6.8.9.2]
b. 25 Mar 1935 d. 24 Sep 1994
9
Valate Elizabeth Stott
[1.2.1.1.3.6.6.8.10]
b. 16 Sep 1909 d. 14 Nov 1997
James Lynn Greenhalgh
b. 2 Apr 1906 d. 23 Jul 1974
10
Anna Udine Greenhalgh
[1.2.1.1.3.6.6.8.10.1]
b. 22 Sep 1930 d. 31 Jul 2014
Norman Rosenberg Lauritzen
b. 21 Feb 1926 d. 11 Mar 1997
11
Norma Lauritzen
[1.2.1.1.3.6.6.8.10.1.1]
b. 16 Aug 1949 d. 20 Jan 2002
+
Maynard Loy Whittington
b. 7 Jul 1935 d. 9 Mar 1990
11
Marion Mark Lauritzen
[1.2.1.1.3.6.6.8.10.1.2]
b. 8 Mar 1952 d. 17 Apr 1957
10
Shirlene Greenhalgh
[1.2.1.1.3.6.6.8.10.2]
b. 29 Sep 1943 d. 31 Dec 2013
Richard Kimball Black
b. 2 Feb 1941 d. 18 Jan 2019
11
Troy Black
[1.2.1.1.3.6.6.8.10.2.1]
+
Beth
11
Kerry Black
[1.2.1.1.3.6.6.8.10.2.2]
+
Meghan
11
Ryan Black
[1.2.1.1.3.6.6.8.10.2.3]
+
Radonna
10
Faye Greenhalgh
[1.2.1.1.3.6.6.8.10.3]
b. 12 Mar 1935 d. 18 Sep 1988
10
Donna Greenhalgh
[1.2.1.1.3.6.6.8.10.4]
10
Carolyn Greenhalgh
[1.2.1.1.3.6.6.8.10.5]
10
Rae Lynn Greenhalgh
[1.2.1.1.3.6.6.8.10.6]
9
Wesley Stott
[1.2.1.1.3.6.6.8.11]
b. 2 Oct 1911 d. 9 Aug 1993
VauNess Thacker
b. 11 Sep 1916 d. 11 Jun 2009
10
Frances Stott
[1.2.1.1.3.6.6.8.11.1]
b. 15 Aug 1937 d. 23 Jul 2017
9
Nelson Stott
[1.2.1.1.3.6.6.8.12]
b. 4 May 1914 d. 17 Apr 1989
Loa Stewart
b. 23 Jun 1917 d. 3 Jan 1998
10
Carlyle Nelson Stott
[1.2.1.1.3.6.6.8.12.1]
b. 13 Apr 1937 d. 26 Jul 2014
10
Ephriam Phillip Stott
[1.2.1.1.3.6.6.8.12.2]
b. 21 Oct 1938 d. 25 Dec 1938
10
Orlynn Stott
[1.2.1.1.3.6.6.8.12.3]
7
Eliza Bushnell
[1.2.1.1.3.6.7]
b. 22 Feb 1826 d. 9 Mar 1867
+
Samson Smith
b. Abt 1839
7
Jane Bushnell
[1.2.1.1.3.6.8]
c. 6 Apr 1828 d. 5 Apr 1898
George Franklin
b. 2 Nov 1829 d. 15 Jul 1907
8
William Franklin
[1.2.1.1.3.6.8.1]
b. 4 Aug 1851 d. 25 Nov 1918
+
Mary Ann Gibbs
c. 10 Oct 1852
8
Elizabeth Franklin
[1.2.1.1.3.6.8.2]
b. 6 Oct 1853 d. 17 Mar 1926
8
Clara H Franklin
[1.2.1.1.3.6.8.3]
b. 21 Nov 1855 d. 26 Jul 1858
8
Charles H Franklin
[1.2.1.1.3.6.8.4]
b. 26 Dec 1857 d. 28 Aug 1927
Elizabeth Brisco
9
Helen Franklin
[1.2.1.1.3.6.8.4.1]
b. 23 Jan 1887
8
Clara Franklin
[1.2.1.1.3.6.8.5]
b. 29 Dec 1859 d. 1900
8
Louisa Clara Franklin
[1.2.1.1.3.6.8.6]
b. Feb 1860 d. 10 May 1878
+
Isaac Brockbank Bushnell
b. 28 Sep 1858 d. 29 May 1877
8
Emily Jane Franklin
[1.2.1.1.3.6.8.7]
b. 12 Nov 1861 d. 23 Mar 1944
+
William Merry
8
George Franklin
[1.2.1.1.3.6.8.8]
b. 12 Oct 1863 d. 1 Jan 1933
+
Emily Pithington
8
Henry Isaac Franklin
[1.2.1.1.3.6.8.9]
b. 4 Jun 1866 d. 31 Oct 1929
+
Kate Penny
8
Alice Florence Franklin
[1.2.1.1.3.6.8.10]
b. 3 Mar 1869 d. 3 Jan 1947
Rachel Metcalfe
b. Bef 6 Jun 1813 d. 6 Sep 1850
7
Thomas Bushnell
[1.2.1.1.3.6.9]
c. 21 Mar 1836 bur. 23 Mar 1837
7
Henry Bushnell
[1.2.1.1.3.6.10]
c. 18 Feb 1838
7
Thomas Bushnell
[1.2.1.1.3.6.11]
c. 22 Nov 1840 bur. 4 Sep 1842
7
Rebecca Bushnell
[1.2.1.1.3.6.12]
b. 1842
7
James Bushnell
[1.2.1.1.3.6.13]
c. 16 Nov 1845 bur. 6 Mar 1846
6
William Bushnell
[1.2.1.1.3.7]
b. 30 Mar 1793
Sarah Walker
b. 1797
7
Harriett Bushnell
[1.2.1.1.3.7.1]
c. 24 Oct 1830
6
Henry Bushnell
[1.2.1.1.3.8]
b. 25 Nov 1796 d. 4 Dec 1796
6
Elizabeth Bushnell
[1.2.1.1.3.9]
b. 2 Mar 1798
6
Anne Bushnell
[1.2.1.1.3.10]
b. 27 Dec 1799 d. 30 Dec 1799
5
George Bushnell
[1.2.1.1.4]
c. 17 Aug 1751
5
Elizabeth Bushnell
[1.2.1.1.5]
c. 11 Nov 1753
Thomas Towersey
c. 14 Jul 1756
6
John Towersey
[1.2.1.1.5.1]
c. 15 Jun 1777
6
Thomas Towersey
[1.2.1.1.5.2]
c. 8 Oct 1780 d. 27 Nov 1855
6
Mary Towersey
[1.2.1.1.5.3]
c. 3 Jul 1781
6
William Towersey
[1.2.1.1.5.4]
c. 1 Dec 1782 bur. 3 Oct 1856
6
James Towersey
[1.2.1.1.5.5]
c. 13 Dec 1786
6
Henry Towersey
[1.2.1.1.5.6]
c. 2 May 1790 d. 3 Jun 1848
6
Elizabeth Towersey
[1.2.1.1.5.7]
c. 1 Feb 1795
5
Francis Bushnell
[1.2.1.1.6]
c. 6 Jun 1756 d. 30 Mar 1829
+
Ann Soanes
b. Abt 1760
5
Thomas Bushnell
[1.2.1.1.7]
c. 16 Apr 1759
5
Henry Bushnell
[1.2.1.1.8]
c. 30 Nov 1761 d. 12 Mar 1837
Elizabeth
b. Abt 1761
6
Sarah Bushnell
[1.2.1.1.8.1]
b. Abt 1794
6
Susanne Bushnell
[1.2.1.1.8.2]
b. Abt 1796
6
Job Bushnell
[1.2.1.1.8.3]
b. 1799 d. 1880
4
Elizabeth Bushnell
[1.2.1.2]
c. 15 Nov 1719
4
Ann Bushnell
[1.2.1.3]
c. 10 Sep 1721 d. 20 Nov 1794
Thomas Trafford
b. 22 Apr 1717 bur. 11 Feb 1776
5
Jacob Trafford
[1.2.1.3.1]
c. 13 Jan 1744 bur. 12 Feb 1744
5
Mary Trafford
[1.2.1.3.2]
c. 5 Jan 1745
+
Richard Pancutt
b. Abt 1745
5
William Trafford
[1.2.1.3.3]
c. 24 Apr 1748 bur. 28 Dec 1785
Anne Kendall
b. Abt 1750
6
William Trafford
[1.2.1.3.3.1]
b. Abt 1775 d. 23 Jul 1775
6
William Trafford
[1.2.1.3.3.2]
c. 24 Nov 1776
Mary Cecil
b. Abt 1780 d. 1806
7
John Cecil Trafford
[1.2.1.3.3.2.1]
c. 26 Apr 1801
Elizabeth Jacob
c. 11 Aug 1782
7
James Trafford
[1.2.1.3.3.2.2]
b. 24 Jan 1803
Harriet Walker
b. 1813
8
Charles Trafford
[1.2.1.3.3.2.2.1]
b. 1831
8
George Trafford
[1.2.1.3.3.2.2.2]
c. 13 Jul 1834
Harriett
b. 1836
9
Elizabeth Trafford
[1.2.1.3.3.2.2.2.1]
b. 1863
9
Tom Trafford
[1.2.1.3.3.2.2.2.2]
b. 1866
9
George H Trafford
[1.2.1.3.3.2.2.2.3]
b. 1867
Emma
b. 1868
10
George H Trafford
[1.2.1.3.3.2.2.2.3.1]
b. 1892
10
Walter J Trafford
[1.2.1.3.3.2.2.2.3.2]
b. 1894
10
May S Trafford
[1.2.1.3.3.2.2.2.3.3]
b. 1896
10
Emily T Trafford
[1.2.1.3.3.2.2.2.3.4]
b. 1898
9
William Trafford
[1.2.1.3.3.2.2.2.4]
b. 1869
9
Caroline Trafford
[1.2.1.3.3.2.2.2.5]
b. 1871
8
William Trafford
[1.2.1.3.3.2.2.3]
c. 11 Nov 1838
Emily
b. 1841
9
Sarah Trafford
[1.2.1.3.3.2.2.3.1]
b. 1868
9
Albert Trafford
[1.2.1.3.3.2.2.3.2]
b. 1871
9
Charles Trafford
[1.2.1.3.3.2.2.3.3]
b. 1873
9
James Trafford
[1.2.1.3.3.2.2.3.4]
b. 1879
8
Elizabeth Trafford
[1.2.1.3.3.2.2.4]
c. 21 Nov 1841
8
Job Trafford
[1.2.1.3.3.2.2.5]
c. 7 May 1844
8
Anne Trafford
[1.2.1.3.3.2.2.6]
c. 7 May 1844
8
Harriet Trafford
[1.2.1.3.3.2.2.7]
c. 11 Oct 1846
7
Robert Trafford
[1.2.1.3.3.2.3]
b. 6 Jul 1806
Ann Goodgame
c. 25 Apr 1813
8
William Trafford
[1.2.1.3.3.2.3.1]
c. 6 Sep 1835
8
Robert Trafford
[1.2.1.3.3.2.3.2]
c. 27 Jul 1845
Amelia Walker
b. 1855
9
Rosa Trafford
[1.2.1.3.3.2.3.2.1]
b. 1872
9
Albert Trafford
[1.2.1.3.3.2.3.2.2]
b. 1873
9
Lily Trafford
[1.2.1.3.3.2.3.2.3]
b. 1875
9
Emily Trafford
[1.2.1.3.3.2.3.2.4]
b. 1875
9
Henry Trafford
[1.2.1.3.3.2.3.2.5]
b. 1880
9
Sarah Trafford
[1.2.1.3.3.2.3.2.6]
b. 1883
9
Walter S Trafford
[1.2.1.3.3.2.3.2.7]
b. 1885
9
Edward Trafford
[1.2.1.3.3.2.3.2.8]
b. 1887
9
Edith M Trafford
[1.2.1.3.3.2.3.2.9]
b. 1889
9
William J Trafford
[1.2.1.3.3.2.3.2.10]
b. Nov 1890
9
Isaac Trafford
[1.2.1.3.3.2.3.2.11]
b. 1891
9
Lizzie Trafford
[1.2.1.3.3.2.3.2.12]
b. 1893
9
Laura Trafford
[1.2.1.3.3.2.3.2.13]
b. 1895
9
Ida Trafford
[1.2.1.3.3.2.3.2.14]
b. 1898
8
Charlotte Trafford
[1.2.1.3.3.2.3.3]
c. 8 Aug 1847
8
Mary Ann Trafford
[1.2.1.3.3.2.3.4]
b. 1850
8
Charles Trafford
[1.2.1.3.3.2.3.5]
b. 1853
8
Emely Trafford
[1.2.1.3.3.2.3.6]
c. 28 Jun 1831
8
Thomas Trafford
[1.2.1.3.3.2.3.7]
c. 6 Oct 1833
Martha
b. 1837
9
Thomas A Trafford
[1.2.1.3.3.2.3.7.1]
b. 1867
9
Sarah S Trafford
[1.2.1.3.3.2.3.7.2]
b. 1869
9
Martha Trafford
[1.2.1.3.3.2.3.7.3]
b. 1871
9
Mary Trafford
[1.2.1.3.3.2.3.7.4]
b. 1873
9
John Trafford
[1.2.1.3.3.2.3.7.5]
b. 1875
9
Mary Trafford
[1.2.1.3.3.2.3.7.6]
b. 1877
9
Martha Trafford
[1.2.1.3.3.2.3.7.7]
b. 1877
9
Maud Trafford
[1.2.1.3.3.2.3.7.8]
b. 1878
9
Ada Trafford
[1.2.1.3.3.2.3.7.9]
b. 1879
9
William Trafford
[1.2.1.3.3.2.3.7.10]
b. 1881
8
Joseph Trafford
[1.2.1.3.3.2.3.8]
c. 4 Mar 1838
8
Charles Trafford
[1.2.1.3.3.2.3.9]
c. 6 Nov 1842
7
Thomas Trafford
[1.2.1.3.3.2.4]
b. 4 May 1808
7
Eliza Trafford
[1.2.1.3.3.2.5]
c. 20 Mar 1818
+
William Coppock
c. 14 Jan 1816 d. 1890
7
William Trafford
[1.2.1.3.3.2.6]
c. 17 Apr 1813
7
Charles Trafford
[1.2.1.3.3.2.7]
c. 5 Apr 1815
7
John Trafford
[1.2.1.3.3.2.8]
c. 23 Apr 1822
6
Mary Trafford
[1.2.1.3.3.3]
c. 13 Sep 1778 bur. 24 Sep 1784
6
Ann Trafford
[1.2.1.3.3.4]
c. 9 Jan 1780
+
Joseph Hedges
b. Abt 1778
6
Jane Trafford
[1.2.1.3.3.5]
c. 21 Sep 1783 d. 21 Jun 1784
6
Jane Trafford
[1.2.1.3.3.6]
c. 3 Jul 1785 bur. 14 Nov 1787
5
Anne Trafford
[1.2.1.3.4]
c. 16 Jun 1751
5
Elizabeth Trafford
[1.2.1.3.5]
c. 8 Apr 1753
John Howes
6
Anne Howse
[1.2.1.3.5.1]
c. 15 Mar 1778
Thomas White
b. 1788
7
Richard White
[1.2.1.3.5.1.1]
b. 1 Dec 1803
Joseph Dennis
b. 1774 bur. 12 Jan 1834
7
John Dennis
[1.2.1.3.5.1.2]
b. 25 May 1808
+
Hannah Phipps
b. 1810
6
Sarah Howse
[1.2.1.3.5.2]
c. 18 Jun 1780
5
Thomas Trafford
[1.2.1.3.6]
c. 25 May 1755
4
Mary Bushnell
[1.2.1.4]
c. 26 Mar 1727 bur. 11 Feb 1808
+
Thomas Trafford
b. Abt 1723
Jacob Trafford
b. 10 May 1719
5
Mary Trafford
[1.2.1.4.1]
b. 25 Mar 1750
Thomas H Shorter
b. 1754 d. 1820
6
Fanny Shorter
[1.2.1.4.1.1]
b. 9 Jul 1775
6
Henry Shorter
[1.2.1.4.1.2]
c. 8 Dec 1776 d. 1793
6
James Shorter
[1.2.1.4.1.3]
c. 14 Feb 1779
Mary Ann
b. Abt 1780
7
Hannah Shorter
[1.2.1.4.1.3.1]
b. 1797 d. 1880
Thomas Currell
b. 1793 bur. 2 Oct 1865
8
Maria Currell
[1.2.1.4.1.3.1.1]
b. 22 Oct 1820 d. 1898
James Cornish
c. 4 Nov 1827 bur. 29 Nov 1906
9
James Cornish
[1.2.1.4.1.3.1.1.1]
b. 4 Jun 1848
9
Sarah Cornish
[1.2.1.4.1.3.1.1.2]
b. 28 Jun 1850
9
Lydia Cornish
[1.2.1.4.1.3.1.1.3]
b. 1851
Tobias Alban Chambers
b. 1855
10
Agnes Mary Chambers
[1.2.1.4.1.3.1.1.3.1]
b. 1883
10
George Chambers
[1.2.1.4.1.3.1.1.3.2]
b. 1886
10
Alice Chambers
[1.2.1.4.1.3.1.1.3.3]
b. 1891
10
Albert Chambers
[1.2.1.4.1.3.1.1.3.4]
b. 1895
9
William Cornish
[1.2.1.4.1.3.1.1.4]
b. 19 May 1853
9
Mary Cornish
[1.2.1.4.1.3.1.1.5]
b. 26 Apr 1855 bur. 15 Dec 1857
9
Rachel Cornish
[1.2.1.4.1.3.1.1.6]
b. 30 Jun 1856
9
Rebecca Cornish
[1.2.1.4.1.3.1.1.7]
b. 25 Nov 1858
9
Joseph Cornish
[1.2.1.4.1.3.1.1.8]
b. 2 Apr 1860 d. 23 Jul 1938
9
Elizabeth Cornish
[1.2.1.4.1.3.1.1.9]
b. 10 Dec 1861
9
Alice Cornish
[1.2.1.4.1.3.1.1.10]
b. 16 Aug 1863
+
John Henry Clements
b. Abt 1863
9
John Cornish
[1.2.1.4.1.3.1.1.11]
b. 18 Aug 1865 d. 8 Mar 1866
9
Hannah Cornish
[1.2.1.4.1.3.1.1.12]
b. 9 Aug 1867
9
Thomas Cornish
[1.2.1.4.1.3.1.1.13]
b. 4 Aug 1870
8
Alice Currell
[1.2.1.4.1.3.1.2]
b. 1822
8
James Currell
[1.2.1.4.1.3.1.3]
b. 1823
+
Rachel Lander
b. 1827
8
Rachel Currell
[1.2.1.4.1.3.1.4]
b. 1824
8
Thomas Currell
[1.2.1.4.1.3.1.5]
b. 1826 d. 1826
8
Thomas Currell
[1.2.1.4.1.3.1.6]
b. 1827
8
Alice Currell
[1.2.1.4.1.3.1.7]
b. 1830
8
John Currell
[1.2.1.4.1.3.1.8]
b. 1831
8
William Currell
[1.2.1.4.1.3.1.9]
b. 1832
Mary
b. 1833
9
Jane Ann Currell
[1.2.1.4.1.3.1.9.1]
b. 1853
Griffin Cresswell
b. 1856 d. 1933
10
Griffin Cresswell
[1.2.1.4.1.3.1.9.1.1]
b. 7 Aug 1880 d. 1949
Louisa Rose Ladd
b. 10 Feb 1884 d. 3 Nov 1954
11
Griffin Cresswell
[1.2.1.4.1.3.1.9.1.1.1]
b. 1907 d. 1908
11
George Cresswell
[1.2.1.4.1.3.1.9.1.1.2]
b. 2 Apr 1909 d. 21 Dec 1962
10
William John Cresswell
[1.2.1.4.1.3.1.9.1.2]
b. 1881
10
Mary Elizabeth Cresswell
[1.2.1.4.1.3.1.9.1.3]
b. 1883
+
Thomas Edward Kelsey
b. 1883
10
Thomas Cresswell
[1.2.1.4.1.3.1.9.1.4]
b. 1885
10
George Cresswell
[1.2.1.4.1.3.1.9.1.5]
b. 1887
10
Agnes Cresswell
[1.2.1.4.1.3.1.9.1.6]
b. 1890
10
Caroline Agnes F Cresswell
[1.2.1.4.1.3.1.9.1.7]
b. 1894
9
Phoebe Currell
[1.2.1.4.1.3.1.9.2]
b. 1866
9
Ellen Currell
[1.2.1.4.1.3.1.9.3]
b. 1869
9
Richard Currell
[1.2.1.4.1.3.1.9.4]
b. 1871
9
Mary Elizabeth Currell
[1.2.1.4.1.3.1.9.5]
b. 1874
9
William Currell
[1.2.1.4.1.3.1.9.6]
b. 1877
9
Henry Currell
[1.2.1.4.1.3.1.9.7]
b. 1880
9
John Currell
[1.2.1.4.1.3.1.9.8]
c. 24 Sep 1860
9
Julia Currell
[1.2.1.4.1.3.1.9.9]
c. 1863
9
William Charles Currell
[1.2.1.4.1.3.1.9.10]
c. 24 Jun 1865 d. 15 Aug 1865
8
Samuel Currell
[1.2.1.4.1.3.1.10]
b. 1835
8
Emanuell Currell
[1.2.1.4.1.3.1.11]
b. 1836
8
Joseph Henry Currell
[1.2.1.4.1.3.1.12]
c. 28 Jun 1837 bur. 17 Sep 1837
8
Alfred Currell
[1.2.1.4.1.3.1.13]
b. 1839 d. 1927
+
Mary Quarterman
b. 1834
8
Rosana Currell
[1.2.1.4.1.3.1.14]
c. 4 Oct 1840 bur. 15 Apr 1843
7
Joseph Shorter
[1.2.1.4.1.3.2]
c. 23 Feb 1800 d. 3 May 1887
7
Rachel Shorter
[1.2.1.4.1.3.3]
c. 31 May 1801
7
James Shorter
[1.2.1.4.1.3.4]
c. 27 Mar 1803
7
Henry Shorter
[1.2.1.4.1.3.5]
b. 1804 d. 13 Dec 1888
7
Richard Shorter
[1.2.1.4.1.3.6]
b. 1804
Susannah Galer
b. Abt 1810
8
Henry Shorter
[1.2.1.4.1.3.6.1]
b. 11 Feb 1833
8
Susanna Shorter
[1.2.1.4.1.3.6.2]
c. 20 Sep 1835
8
Richard Shorter
[1.2.1.4.1.3.6.3]
c. 2 Dec 1838
8
Elinor Shorter
[1.2.1.4.1.3.6.4]
c. 8 Nov 1840
8
Rosanna Shorter
[1.2.1.4.1.3.6.5]
c. 8 Jan 1843
8
Mary Ann Shorter
[1.2.1.4.1.3.6.6]
c. 14 Nov 1847
George Dipper
b. 1846 d. 1895
9
Beatrice Dipper
[1.2.1.4.1.3.6.6.1]
b. 1873
9
Bertha Selina Dipper
[1.2.1.4.1.3.6.6.2]
b. 1876
9
Frances Eleanor Dipper
[1.2.1.4.1.3.6.6.3]
b. 1878
9
Albert George Dipper
[1.2.1.4.1.3.6.6.4]
b. 1880 d. 1884
8
Emily Shorter
[1.2.1.4.1.3.6.7]
c. 12 Mar 1852
7
James Shorter
[1.2.1.4.1.3.7]
b. 12 May 1805
7
Mary Shorter
[1.2.1.4.1.3.8]
c. 1 Aug 1808 bur. 19 Mar 1809
7
William Shorter
[1.2.1.4.1.3.9]
d. 11 Dec 1816
6
Thomas Shorter
[1.2.1.4.1.4]
c. 21 May 1780
6
Rachel Shorter
[1.2.1.4.1.5]
c. 28 Apr 1782 bur. 12 Aug 1785
6
Molly Shorter
[1.2.1.4.1.6]
c. 25 Mar 1785
6
William Shorter
[1.2.1.4.1.7]
c. 26 May 1787 bur. 20 Jan 1788
6
William Shorter
[1.2.1.4.1.8]
c. 21 Mar 1790 bur. 10 Apr 1791
6
Richard Shorter
[1.2.1.4.1.9]
c. 2 Jun 1791 bur. 19 Jul 1795
5
Sarah Trafford
[1.2.1.4.2]
b. 29 Sep 1751
5
Martha Trafford
[1.2.1.4.3]
b. 27 May 1753 d. 15 Jul 1753
5
Martha Trafford
[1.2.1.4.4]
b. 27 Jul 1755
5
Elizabeth Trafford
[1.2.1.4.5]
b. 25 Dec 1759 d. 1 Jun 1760
5
Jacob Trafford
[1.2.1.4.6]
b. 19 Jul 1761 d. 26 Jan 1766
5
John Trafford
[1.2.1.4.7]
b. 11 Sep 1763 bur. 28 Nov 1821
Charlotte Harpur
b. 16 Mar 1764 bur. 4 Jan 1841
6
John Trafford
[1.2.1.4.7.1]
b. 1796
Ann Harris
b. 1 Dec 1793 d. 19 May 1865
7
Henry Trafford
[1.2.1.4.7.1.1]
c. 12 Nov 1815 d. 7 Oct 1886
Anne Davis
b. 1817
8
James Trafford
[1.2.1.4.7.1.1.1]
c. 3 Aug 1837 bur. 17 Sep 1837
8
Thomas Trafford
[1.2.1.4.7.1.1.2]
c. 3 Aug 1837 bur. 17 Sep 1837
8
William Henry Trafford
[1.2.1.4.7.1.1.3]
b. 1839
8
Sarah Ann Trafford
[1.2.1.4.7.1.1.4]
b. 1842
Joseph Robert Messenger
b. 31 Aug 1845
9
Joseph William Messenger
[1.2.1.4.7.1.1.4.1]
c. 28 Dec 1868
9
Frederick James Messenger
[1.2.1.4.7.1.1.4.2]
b. 1870 d. 11 Dec 1870
9
Annie Louisa Messenger
[1.2.1.4.7.1.1.4.3]
b. Apr 1872 d. Aft 1911
9
Julie Messenger
[1.2.1.4.7.1.1.4.4]
c. 13 Sep 1874 d. 16 Dec 1874
9
Edith Kate Messenger
[1.2.1.4.7.1.1.4.5]
c. 16 Apr 1875 d. 2 May 1876
9
Emily Edith Messenger
[1.2.1.4.7.1.1.4.6]
c. 1 Jul 1877
Frederick Cartlidge
b. 1871 d. Abt 1905
10
Albert Victor William Cartlidge
[1.2.1.4.7.1.1.4.6.1]
b. 1898 d. Aft 1911
10
Frederick Joseph Cartlidge
[1.2.1.4.7.1.1.4.6.2]
b. Abt Jul 1899 d. Aft 1923
10
Vera Emily M Cartlidge
[1.2.1.4.7.1.1.4.6.3]
b. Abt 1904
9
Robert Henry Messenger
[1.2.1.4.7.1.1.4.7]
b. 1879 d. 15 Oct 1879
8
George Trafford
[1.2.1.4.7.1.1.5]
c. 10 Jan 1847 bur. 11 Dec 1853
8
Samuel Trafford
[1.2.1.4.7.1.1.6]
c. 18 Mar 1849 bur. 11 Jun 1851
8
Joseph Trafford
[1.2.1.4.7.1.1.7]
c. 6 Jun 1851 bur. 27 Dec 1851
8
Joseph Trafford
[1.2.1.4.7.1.1.8]
b. 12 Mar 1853
8
George Samuel Trafford
[1.2.1.4.7.1.1.9]
c. 6 Apr 1856
Emma
b. 1857
9
Henry James Trafford
[1.2.1.4.7.1.1.9.1]
c. 18 Aug 1878 d. Abt 1916
9
William George Trafford
[1.2.1.4.7.1.1.9.2]
c. 12 Sep 1880
9
Arthur Trafford
[1.2.1.4.7.1.1.9.3]
b. 1884
9
Alfred Trafford
[1.2.1.4.7.1.1.9.4]
b. 1890
9
Frederick John Trafford
[1.2.1.4.7.1.1.9.5]
b. 4 Sep 1890 d. 28 Dec 1958
Minnie M Hamilton
b. Abt 1893
10
Ervan Harold Trafford
[1.2.1.4.7.1.1.9.5.1]
b. 31 May 1916 d. 29 Nov 1933
10
Kathleen May Trafford
[1.2.1.4.7.1.1.9.5.2]
b. 2 Jan 1918 d. 10 Jan 2006
+
Harvey Malcolm Sinclair
b. 20 Apr 1908 d. 5 May 1970
10
Clarence F Trafford
[1.2.1.4.7.1.1.9.5.3]
b. 1919 d. 1989
10
Alvin Edward Trafford
[1.2.1.4.7.1.1.9.5.4]
b. 3 Aug 1926 d. 10 Nov 1984
9
Beatrice Trafford
[1.2.1.4.7.1.1.9.6]
b. 1892
7
John Trafford
[1.2.1.4.7.1.2]
c. 13 Jan 1822
+
Mary Phillips
b. Abt 1822
7
Frederick Trafford
[1.2.1.4.7.1.3]
c. 14 Dec 1823 d. 1907
Elizabeth Evans
c. 28 Aug 1825
8
Mary Elizabeth Trafford
[1.2.1.4.7.1.3.1]
b. 1848
8
John Trafford
[1.2.1.4.7.1.3.2]
b. 1851
Harriet Hall
b. 1852
9
Elizabeth Trafford
[1.2.1.4.7.1.3.2.1]
b. 26 Dec 1877
+
Frederick Adolphus Walker
b. 1877
9
John Trafford
[1.2.1.4.7.1.3.2.2]
b. 1879
9
Alice Lily May Trafford
[1.2.1.4.7.1.3.2.3]
b. 1882
+
Joseph Arthur Peacock
b. 1882
8
Charlotte Trafford
[1.2.1.4.7.1.3.3]
b. 1854
8
George Trafford
[1.2.1.4.7.1.3.4]
b. Aug 1856 d. Sep 1856
8
Emely Trafford
[1.2.1.4.7.1.3.5]
b. 4 Dec 1857
8
Alfred Trafford
[1.2.1.4.7.1.3.6]
b. 8 Jul 1860 d. 2 Apr 1932
Alice Eason Jenkins
b. 9 Mar 1859 d. Aft May 1899
9
Alice Trafford
[1.2.1.4.7.1.3.6.1]
b. 1882 d. Abt 1930
+
Henry Walter Phillips
b. 1882
9
Frederick Trafford
[1.2.1.4.7.1.3.6.2]
b. 1883 d. 27 May 1937
Rosie Annie Simmons
b. Jun 1878 d. 18 Apr 1917
10
Emma Trafford
[1.2.1.4.7.1.3.6.2.1]
b. Mar 1907 d. Mar 1907
10
Gladys Rose Trafford
[1.2.1.4.7.1.3.6.2.2]
b. 2 Jan 1908 d. 1958
Herbert Barber
b. 5 Jun 1903 d. Abt 1975
11
Son Barber
[1.2.1.4.7.1.3.6.2.2.1]
b. 1936 d. 1936
10
Frederick Walter Trafford
[1.2.1.4.7.1.3.6.2.3]
b. 12 May 1910 d. Sep 1996
+
Barbara Webb
b. 1908 d. 1981
10
Ethel Trafford
[1.2.1.4.7.1.3.6.2.4]
b. 13 Dec 1911 d. Oct 2005
9
Alfred Trafford
[1.2.1.4.7.1.3.6.3]
b. 31 Jan 1888 d. 7 Feb 1951
Florence Edith Pretty
b. 14 Jul 1885 d. 17 Aug 1967
10
Florence Alice Trafford
[1.2.1.4.7.1.3.6.3.1]
b. 15 Jul 1911 d. 5 Sep 2001
Gilbert Barber
b. 5 Jun 1903 d. 13 Feb 1980
11
Alan Gilbert Barber
[1.2.1.4.7.1.3.6.3.1.1]
b. 13 May 1933 d. 7 Feb 1960
11
Roy Barber
[1.2.1.4.7.1.3.6.3.1.2]
b. 16 Feb 1935 d. 6 Oct 2014
10
Doris Eva Trafford
[1.2.1.4.7.1.3.6.3.2]
b. 30 Apr 1913 d. 1970
+
George Albert Lambert
b. 1911 d. 15 Aug 1950
10
Alfred Frederick Trafford
[1.2.1.4.7.1.3.6.3.3]
b. Nov 1915 d. 1971
+
Doll Clark
b. 1912 d. 1980
10
Ivy Eleanor Trafford
[1.2.1.4.7.1.3.6.3.4]
b. 1917 d. 25 Mar 1919
10
Leonard Horace Trafford
[1.2.1.4.7.1.3.6.3.5]
b. Apr 1919 d. 1971
10
William Charles Trafford
[1.2.1.4.7.1.3.6.3.6]
b. 25 Oct 1920 d. Aug 2002
9
William Trafford
[1.2.1.4.7.1.3.6.4]
b. 10 Dec 1889 d. 2 Mar 1954
Mary Vance
b. 1889 d. Abt 1980
10
Lillian Theresa Trafford
[1.2.1.4.7.1.3.6.4.1]
b. 1914 d. 1915
10
Cecilia Trafford
[1.2.1.4.7.1.3.6.4.2]
b. 1916 d. 22 Jul 1991
10
Veronica Trafford
[1.2.1.4.7.1.3.6.4.3]
b. 1919 d. 18 Oct 1954
10
Theresa Trafford
[1.2.1.4.7.1.3.6.4.4]
b. 25 Mar 1920 d. 1995
10
Patricia Trafford
[1.2.1.4.7.1.3.6.4.5]
b. 14 Jul 1925 d. Abt 1980
9
Elizabeth Trafford
[1.2.1.4.7.1.3.6.5]
b. 20 Feb 1892 d. 1 Apr 1963
9
Emma Trafford
[1.2.1.4.7.1.3.6.6]
b. 1893 d. 1960
9
Rose Trafford
[1.2.1.4.7.1.3.6.7]
b. 1897 d. 13 Dec 1983
9
Lillian Trafford
[1.2.1.4.7.1.3.6.8]
b. 2 Apr 1899 d. 11 Nov 1939
+
Mildred Alice Gray
b. Jun 1863
8
Sarah Ann Trafford
[1.2.1.4.7.1.3.7]
b. 1864
8
Henry William Trafford
[1.2.1.4.7.1.3.8]
b. 1867
7
Eliza Trafford
[1.2.1.4.7.1.4]
b. 1826
John Thomas Blanchett
b. 1812
8
John Trafford Blanchett
[1.2.1.4.7.1.4.1]
b. 1849 d. 1881
+
Ellen Jane Tooton
b. 1847
7
Anne Trafford
[1.2.1.4.7.1.5]
c. 13 Jul 1828
7
Thomas Trafford
[1.2.1.4.7.1.6]
c. 3 Aug 1831
7
George Trafford
[1.2.1.4.7.1.7]
c. 12 Jan 1834 d. 20 Mar 1836
7
Emily Trafford
[1.2.1.4.7.1.8]
c. 6 Sep 1835
7
Jane Trafford
[1.2.1.4.7.1.9]
c. 5 Feb 1837
7
John Trafford
[1.2.1.4.7.1.10]
c. 10 Jul 1814 d. 14 Aug 1814
7
Sarah Trafford
[1.2.1.4.7.1.11]
c. 21 Dec 1817
7
Alice Trafford
[1.2.1.4.7.1.12]
c. 6 Feb 1820 d. 28 Jul 1876
Frederick Blanchett
b. 1829
8
Thomas Blanchett
[1.2.1.4.7.1.12.1]
c. 27 May 1849
8
Emily J Blanchett
[1.2.1.4.7.1.12.2]
b. 1851
8
George Richard Blanchett
[1.2.1.4.7.1.12.3]
b. 1853
8
Henry Blanchett
[1.2.1.4.7.1.12.4]
b. 1853
8
Thirza Alma Blanchett
[1.2.1.4.7.1.12.5]
b. 1855
8
Emily Blanchett
[1.2.1.4.7.1.12.6]
b. 1856
8
Frederick Blanchett
[1.2.1.4.7.1.12.7]
b. 1858
8
Eliza Blanchett
[1.2.1.4.7.1.12.8]
b. 1861
8
Augusta Blanchett
[1.2.1.4.7.1.12.9]
b. 1863
8
Selina Blanchett
[1.2.1.4.7.1.12.10]
b. 1866
6
Joseph Trafford
[1.2.1.4.7.2]
c. 26 Jul 1789 d. 21 Apr 1793
6
Joseph Trafford
[1.2.1.4.7.3]
c. 9 Jul 1793 d. 16 Dec 1802
6
Jacob Trafford
[1.2.1.4.7.4]
c. 10 Oct 1802 bur. 2 Mar 1854
Elizabeth Blanchett
b. Abt 1802
7
Mary Ann Trafford
[1.2.1.4.7.4.1]
b. 1836
7
Jacob Henry Trafford
[1.2.1.4.7.4.2]
b. 1839
Rhoda Morris
c. 26 Nov 1837
8
Willoughby Trafford
[1.2.1.4.7.4.2.1]
b. 1858
Sarah Ellen Emma Parsons
b. 1860
9
Ernest Christopher Trafford
[1.2.1.4.7.4.2.1.1]
c. 22 Jul 1884 d. 27 Mar 1961
9
Margaret Ellen Trafford
[1.2.1.4.7.4.2.1.2]
c. 15 Apr 1886
9
William Arthur Thomas Trafford
[1.2.1.4.7.4.2.1.3]
c. 18 Dec 1887 d. 25 Sep 1915
9
Lillian Bessie Trafford
[1.2.1.4.7.4.2.1.4]
c. 27 Apr 1890 bur. 13 Aug 1890
9
Annie Elizabeth Trafford
[1.2.1.4.7.4.2.1.5]
c. 16 Feb 1892 bur. 27 Mar 1892
9
Arthur Trafford
[1.2.1.4.7.4.2.1.6]
c. 16 Feb 1892 bur. 22 Feb 1892
8
Aubrey Charles Trafford
[1.2.1.4.7.4.2.2]
b. 1861
8
Ernest Arthur Trafford
[1.2.1.4.7.4.2.3]
b. 1863 bur. 4 Mar 1917
8
Elizabeth Mary Trafford
[1.2.1.4.7.4.2.4]
b. 1866 bur. 9 Mar 1938
8
Henry Herbert Trafford
[1.2.1.4.7.4.2.5]
b. 1868 d. 27 Mar 1955
Edith Jane Duffield
b. Mar 1868 d. 1952
9
Edith Florence Trafford
[1.2.1.4.7.4.2.5.1]
b. 1895 d. 1895
9
Henry John Trafford
[1.2.1.4.7.4.2.5.2]
b. 3 Jun 1897 d. 1979
9
Nellie Victoria Alice Trafford
[1.2.1.4.7.4.2.5.3]
b. 5 Jun 1900 d. 28 Sep 1982
9
George Trafford
[1.2.1.4.7.4.2.5.4]
b. 1903 d. 1904
9
Frederick Trafford
[1.2.1.4.7.4.2.5.5]
b. 1905 d. 1907
8
Pamela Jane Trafford
[1.2.1.4.7.4.2.6]
b. Mar 1870
Frederick Coles
b. 1863
9
Alice Coles
[1.2.1.4.7.4.2.6.1]
b. 1896
9
Frank Coles
[1.2.1.4.7.4.2.6.2]
b. Oct 1900
8
Edward Trafford
[1.2.1.4.7.4.2.7]
b. 1874 d. 8 Dec 1958
Sarah Ellen Surman
b. Abt 1879 d. 8 Jan 1955
9
Ernest Arthur Trafford
[1.2.1.4.7.4.2.7.1]
b. 27 Nov 1898 d. 26 Dec 1963
9
Alice May Trafford
[1.2.1.4.7.4.2.7.2]
b. Abt 1902 d. 23 Apr 1960
+
Edward Woodbridge Hedges
b. Abt 1900 bur. Sep 1990
9
Ethel Annie Trafford
[1.2.1.4.7.4.2.7.3]
b. 8 Aug 1904 d. 6 Dec 1979
9
Evelyn Gladys Trafford
[1.2.1.4.7.4.2.7.4]
b. Jun 1909 d. 16 Nov 1997
8
Alice Mary Trafford
[1.2.1.4.7.4.2.8]
b. 1876
+
Goss
b. Abt 1874
8
George Percy Trafford
[1.2.1.4.7.4.2.9]
c. 14 Sep 1879 d. 11 Oct 1900
6
Phoebe Trafford
[1.2.1.4.7.5]
c. 10 Nov 1805
6
James Trafford
[1.2.1.4.7.6]
c. 2 Aug 1807
Ruth Higgins
b. 1810 d. 20 Apr 1864
7
Joseph George Trafford
[1.2.1.4.7.6.1]
c. 6 Feb 1831 d. 1897
Mary Magarity
b. Abt 1830 d. 29 Oct 1923
8
James George Trafford
[1.2.1.4.7.6.1.1]
b. 1856 d. 20 Sep 1921
Bridget Widge
b. 1863 d. 10 Sep 1916
9
Annie Trafford
[1.2.1.4.7.6.1.1.1]
b. 1883 d. 1950
Alexander Dalgleish
b. 1884 d. 1944
10
Alexander James Dalgleish
[1.2.1.4.7.6.1.1.1.1]
b. 1906 d. 1983
10
Ruth Isobella Dalgleish
[1.2.1.4.7.6.1.1.1.2]
b. 1908 d. 1982
9
Elizabeth Ruth Trafford
[1.2.1.4.7.6.1.1.2]
b. 16 Aug 1885 d. 1886
9
Elizabeth Ruth Trafford
[1.2.1.4.7.6.1.1.3]
b. 21 Oct 1887 d. 2 Jul 1941
+
Charles Edwin Yelland
b. 26 Oct 1883 d. 7 Mar 1965
9
William George Trafford
[1.2.1.4.7.6.1.1.4]
b. 1889 d. 1964
Ellen Annie Spence
10
William George Trafford
[1.2.1.4.7.6.1.1.4.1]
b. 1921 d. 1973
9
Sarah Jane Trafford
[1.2.1.4.7.6.1.1.5]
b. 1891 d. 1952
William Andrew Dalgleish
b. 1896 d. 5 Aug 1955
10
William Thomas Dalgleish
[1.2.1.4.7.6.1.1.5.1]
b. 1919 d. 1984
10
David James Dalgleish
[1.2.1.4.7.6.1.1.5.2]
b. 1922 d. 1933
10
Nellie Dalgleish
[1.2.1.4.7.6.1.1.5.3]
b. 1925 d. 1971
9
Maggie May Trafford
[1.2.1.4.7.6.1.1.6]
b. 1894
9
Peter James Trafford
[1.2.1.4.7.6.1.1.7]
b. 1902 d. 1959
8
William Henry Trafford
[1.2.1.4.7.6.1.2]
b. 1857 d. 6 Aug 1935
Alice Chappell
b. Abt 1860 d. 16 Apr 1940
9
Arthur Trafford
[1.2.1.4.7.6.1.2.1]
b. 28 Jun 1885
8
Elizabeth Ruth Trafford
[1.2.1.4.7.6.1.3]
b. 7 Aug 1859 d. 1914
Edmund Brister
b. 1854 d. 1889
9
William Henry Brister
[1.2.1.4.7.6.1.3.1]
b. 1890
Ruby Quirke
b. 1890
10
Ruby Mary Brister
[1.2.1.4.7.6.1.3.1.1]
b. 1915 d. 1915
9
Theresa Mary Brister
[1.2.1.4.7.6.1.3.2]
b. 1892
9
Gladys Myrtle Brister
[1.2.1.4.7.6.1.3.3]
b. 1901
8
John Emanuel Trafford
[1.2.1.4.7.6.1.4]
b. 20 Jan 1862 bur. 1899
Mary Alice Jones
b. 1875 d. 21 Feb 1936
9
Mary Ellen Trafford
[1.2.1.4.7.6.1.4.1]
b. 1890 d. 1891
9
Mary Florence Trafford
[1.2.1.4.7.6.1.4.2]
b. 1891 d. 1891
9
John Herbert Trafford
[1.2.1.4.7.6.1.4.3]
b. 1892 d. 10 Nov 1962
+
Dorothy Linda May Cross
b. 1908 d. 1982
9
Ethel May Trafford
[1.2.1.4.7.6.1.4.4]
b. 1896
9
Thomas Henry Trafford
[1.2.1.4.7.6.1.4.5]
b. 1898 d. 9 Apr 1965
9
Violet Irene Trafford
[1.2.1.4.7.6.1.4.6]
b. 1901
8
Theresa Trafford
[1.2.1.4.7.6.1.5]
b. 5 Jul 1865
Stephen Joseph Skepper
b. 1865
9
Mary Agnes Skepper
[1.2.1.4.7.6.1.5.1]
b. 1890
9
Maud Skepper
[1.2.1.4.7.6.1.5.2]
b. 1895 d. 1895
9
Ivy Skepper
[1.2.1.4.7.6.1.5.3]
b. 1896
9
Harold Skepper
[1.2.1.4.7.6.1.5.4]
b. 1900
8
Susan Sarah Trafford
[1.2.1.4.7.6.1.6]
b. 1867
8
Joseph Trafford
[1.2.1.4.7.6.1.7]
b. 1869 d. 1931
Mary Jane Matheson
b. 1870 d. 1963
9
Olive Mary Trafford
[1.2.1.4.7.6.1.7.1]
b. 1899
+
Joseph Alexander Nimon
9
Violet Elizabeth Trafford
[1.2.1.4.7.6.1.7.2]
b. 1900 d. 21 Jan 1901
9
Joseph Duncan Trafford
[1.2.1.4.7.6.1.7.3]
b. 1903 d. 1957
8
Mary Ann Trafford
[1.2.1.4.7.6.1.8]
b. 1871
William Tracy
b. 1871
9
William Joseph Tracy
[1.2.1.4.7.6.1.8.1]
b. 1900
8
Job Trafford
[1.2.1.4.7.6.1.9]
b. 1873 d. 1962
8
Thomas Ruby Trafford
[1.2.1.4.7.6.1.10]
b. 1877 d. 1942
+
Annie Elizabeth Stokoe
+
Agnes Frances Taylor
7
Emanuel Trafford
[1.2.1.4.7.6.2]
c. 18 Aug 1833 d. 24 Jun 1887
Isobella James Baker Hall
b. 1846
8
Susanna Isobella Trafford
[1.2.1.4.7.6.2.1]
b. 1867
8
James William Trafford
[1.2.1.4.7.6.2.2]
b. 1868 d. 1946
+
Emma Harriet Jane Powell
b. Abt 1877 d. 1930
8
Joseph Job Trafford
[1.2.1.4.7.6.2.3]
b. 1870
8
Elizabeth Trafford
[1.2.1.4.7.6.2.4]
b. 1872
8
Albert Edward Trafford
[1.2.1.4.7.6.2.5]
b. 1875 d. 1955
Margaret Joyce
9
Frederick Trafford
[1.2.1.4.7.6.2.5.1]
b. 1899 d. 1899
9
Florence Victoria Adelaide Trafford
[1.2.1.4.7.6.2.5.2]
b. 1900
9
Bernard Leslie Trafford
[1.2.1.4.7.6.2.5.3]
b. 1902 d. 1964
9
Rita May Trafford
[1.2.1.4.7.6.2.5.4]
b. 1904
8
Florence Louisa Trafford
[1.2.1.4.7.6.2.6]
b. 1877
Salvanos Hill
b. 1877 d. 1899
9
Reginald Hall Hill
[1.2.1.4.7.6.2.6.1]
b. 1912 d. 1914
8
Victoria Adelaide Trafford
[1.2.1.4.7.6.2.7]
b. 1880
8
Edwin Trafford
[1.2.1.4.7.6.2.8]
b. 1883
8
Emanuel Trafford
[1.2.1.4.7.6.2.9]
b. 1885
7
Kezia Trafford
[1.2.1.4.7.6.3]
c. 21 Aug 1836 d. 11 Nov 1891
Thomas Francis Kilby Dell
b. 26 May 1832 d. 21 Apr 1890
8
Elizabeth Caroline Dell
[1.2.1.4.7.6.3.1]
b. 1852
Thomas Todd
b. 1852
9
Alla Todd
[1.2.1.4.7.6.3.1.1]
b. 1871
9
Thomas Todd
[1.2.1.4.7.6.3.1.2]
b. 1872 d. 1872
9
Arthur Thomas Todd
[1.2.1.4.7.6.3.1.3]
b. 1874
9
George William Todd
[1.2.1.4.7.6.3.1.4]
b. 1877
9
ALfred Henry Todd
[1.2.1.4.7.6.3.1.5]
b. 1878 d. 1879
9
Ethel Kezia Todd
[1.2.1.4.7.6.3.1.6]
b. 1883
9
Herbert Matthew Todd
[1.2.1.4.7.6.3.1.7]
b. 1885
9
Ann Musgrove Todd
[1.2.1.4.7.6.3.1.8]
b. 1887
8
Matilda Dell
[1.2.1.4.7.6.3.2]
b. 1854
8
Francis Kirby Dell
[1.2.1.4.7.6.3.3]
b. 1857 d. 27 Oct 1933
Jane Amelia Sterritt
b. 1854 d. 19 Feb 1920
9
Christina Ada Dell
[1.2.1.4.7.6.3.3.1]
b. Abt 1874 d. 8 Aug 1949
John Henry Heap
b. 1865 d. 17 May 1930
10
Arthur Joseph Heap
[1.2.1.4.7.6.3.3.1.1]
b. 31 Oct 1898 d. 1965
10
William Albert Hopeton Heap
[1.2.1.4.7.6.3.3.1.2]
b. 1900 d. Bef 1930
10
Farancis Kilby Heap
[1.2.1.4.7.6.3.3.1.3]
b. 1902 d. Bef 1930
10
Gordon Keith Heap
[1.2.1.4.7.6.3.3.1.4]
b. 16 Aug 1907 d. Aug 1976
10
Hedley Alfred Heap
[1.2.1.4.7.6.3.3.1.5]
b. 1911
9
Ethel May Dell
[1.2.1.4.7.6.3.3.2]
b. 1880 d. 25 Dec 1961
Frederick Fordham
b. 1874 d. 15 Jun 1962
10
Arthur Leslie Fordham
[1.2.1.4.7.6.3.3.2.1]
b. 1903 d. 1966
10
Albert William Fordham
[1.2.1.4.7.6.3.3.2.2]
b. 1906 d. 10 Jun 1919
10
Francis George Fordham
[1.2.1.4.7.6.3.3.2.3]
b. 9 Oct 1907 d. 8 Aug 1991
+
Constance Victoria Johns
b. 25 Nov 1905 d. 11 Oct 2006
10
Amelia May Fordham
[1.2.1.4.7.6.3.3.2.4]
b. 1909 d. 1911
9
William Thomas Francis Dell
[1.2.1.4.7.6.3.3.3]
b. 28 Jan 1882 d. 18 Apr 1953
Louisa Burnett Harriet Chapman
b. 13 Jan 1883 d. 11 Dec 1941
10
Francis William Jesse Dell
[1.2.1.4.7.6.3.3.3.1]
b. 1908 d. 1909
10
Jessie Amelia Dell
[1.2.1.4.7.6.3.3.3.2]
b. 22 Dec 1909 d. 12 Nov 2001
+
Alfred John Thomas Winter
b. 1896 d. 16 Jun 1983
10
William Bramwell Dell
[1.2.1.4.7.6.3.3.3.3]
b. 27 Jan 1913 d. 23 Sep 2008
+
Daisy Elva Potter
b. 31 May 1923 d. 21 Nov 2007
+
Veronica Tavener
b. 8 Jun 1915 d. 18 Nov 1999
10
Hazel Bruce Dell
[1.2.1.4.7.6.3.3.3.4]
b. 28 Mar 1918 d. 10 Feb 2009
Aubrey Howard Maling Carnell
b. 4 Apr 1914 d. 15 Nov 2010
11
Living
[1.2.1.4.7.6.3.3.3.4.1]
+
Charlotte Jane Day
9
Florence Mabel Myna Dell
[1.2.1.4.7.6.3.3.4]
b. 9 Feb 1884 d. 24 May 1954
Amos Alex Clarency Preston
b. 1872 d. 13 Oct 1956
10
Amelia Florence Preston
[1.2.1.4.7.6.3.3.4.1]
b. 3 Jan 1908 d. 27 Jan 1979
+
Leslie Alfred Brudenell
b. 11 Jan 1908 d. 27 Jun 2008
10
Georgina Preston
[1.2.1.4.7.6.3.3.4.2]
b. 1909
+
Frederick George Watkinson
b. 24 Jan 1903 d. 1982
10
George Arthur Campbell Preston
[1.2.1.4.7.6.3.3.4.3]
b. 1910 d. 1982
10
Hedley Alfred Irwin Preston
[1.2.1.4.7.6.3.3.4.4]
b. 29 Mar 1913 d. 20 Jan 2007
+
Beatrice Lucy Firth
b. 11 Sep 1913
10
Ada Beryl Preston
[1.2.1.4.7.6.3.3.4.5]
b. 24 Apr 1915 d. 12 Jul 2010
+
Thomas Keith Hunter
b. 15 Dec 1913 d. 26 Aug 2001
10
Francis Kilby Preston
[1.2.1.4.7.6.3.3.4.6]
b. 1916 d. 26 Sep 1918
10
Gwendoline Francis Muriel Preston
[1.2.1.4.7.6.3.3.4.7]
b. 1919 d. 1933
9
Joseph Eddie Dell
[1.2.1.4.7.6.3.3.5]
b. 1886 d. 3 Dec 1960
Emma Ann Skinner
b. 1884 d. 17 Jul 1976
10
Arthur Leslie Dell
[1.2.1.4.7.6.3.3.5.1]
b. 1907 d. 1933
+
Doris Isabel Cameron
b. Abt 1908
10
Ernest Joseph William Dell
[1.2.1.4.7.6.3.3.5.2]
b. 1909 d. 25 Nov 1971
+
Margaret Elizabeth Rogers
b. 1911 d. 1974
9
Arthur Henry Dell
[1.2.1.4.7.6.3.3.6]
b. 1888 d. 16 Jan 1894
9
Rose Elizabeth Dell
[1.2.1.4.7.6.3.3.7]
b. 1890 d. Mar 1962
James Joseph Lord
b. 1892 d. 19 Dec 1976
10
Mavis Joyce Lord
[1.2.1.4.7.6.3.3.7.1]
b. 1917 d. 1938
10
Living
[1.2.1.4.7.6.3.3.7.2]
9
Edward Dell
[1.2.1.4.7.6.3.3.8]
b. 1890 d. 1907
9
Hedley Alfred Dell
[1.2.1.4.7.6.3.3.9]
b. 1891 d. 21 May 1908
9
Kezia Dell
[1.2.1.4.7.6.3.3.10]
b. 1893 d. 1893
8
Henry Thomas Dell
[1.2.1.4.7.6.3.4]
b. 1859 d. 1913
Margaret Elizabeth Pearson
b. 1862 d. 1945
9
Thomas Francis Kilby Dell
[1.2.1.4.7.6.3.4.1]
b. 1881 d. 1921
9
William Henry Dell
[1.2.1.4.7.6.3.4.2]
b. 1883 d. 1918
+
Caroline Annie Trahar
b. 1880
9
Grace Elizabeth Dell
[1.2.1.4.7.6.3.4.3]
b. 1885 d. 4 Jul 1968
+
Thomas Arthur Treeby
9
Alice Maud Myra Dell
[1.2.1.4.7.6.3.4.4]
b. 1887 d. 1971
George Gingell
b. 1885 d. 19 Oct 1975
10
Mavis Gingell
[1.2.1.4.7.6.3.4.4.1]
b. 1908 d. 1965
10
Margaret Joyce Gingell
[1.2.1.4.7.6.3.4.4.2]
b. 1910 d. 1974
10
Eunice Gingell
[1.2.1.4.7.6.3.4.4.3]
b. 1913 d. 1913
10
Norman Gingell
[1.2.1.4.7.6.3.4.4.4]
b. 1917 d. 1917
10
Douglas Gingell
[1.2.1.4.7.6.3.4.4.5]
b. 1917 d. 1917
9
Nora Margaret Dell
[1.2.1.4.7.6.3.4.5]
b. 1890
9
Oscar Trafford Dell
[1.2.1.4.7.6.3.4.6]
b. 1893
9
Alfred John Dell
[1.2.1.4.7.6.3.4.7]
b. 1895
8
Amelia Emily Dell
[1.2.1.4.7.6.3.5]
b. 1861
8
Alfred John Dell
[1.2.1.4.7.6.3.6]
b. 1864
8
Edmund Blyton Dell
[1.2.1.4.7.6.3.7]
b. 1866 d. 1873
8
Arthur William Dell
[1.2.1.4.7.6.3.8]
b. 1868
8
Rachel Dell
[1.2.1.4.7.6.3.9]
b. 10 Apr 1871
8
Edmond Blighton Dell
[1.2.1.4.7.6.3.10]
b. 1874
7
Thirsa Trafford
[1.2.1.4.7.6.4]
b. Abt 1840 d. 1874
John Hopper
b. 1840
8
Phoebe Ann Hopper
[1.2.1.4.7.6.4.1]
b. 1859
8
Henry James Hopper
[1.2.1.4.7.6.4.2]
b. 1861
Mary Jane Miller
b. 1866 d. 1921
9
Annie Hopper
[1.2.1.4.7.6.4.2.1]
b. 1884 d. 1979
9
Phoebe Hopper
[1.2.1.4.7.6.4.2.2]
b. 1885 d. 1977
9
May Lilian Hopper
[1.2.1.4.7.6.4.2.3]
b. 1888 d. 1973
9
Henry Cyril Hopper
[1.2.1.4.7.6.4.2.4]
b. 1890 d. 1967
9
Hazel Marion Opal Hopper
[1.2.1.4.7.6.4.2.5]
b. 1896 d. 1978
8
Edward Walter Hopper
[1.2.1.4.7.6.4.3]
b. Abt 1864 d. 1924
+
Mary Deed
b. 1886 d. 1960
8
John William Hopper
[1.2.1.4.7.6.4.4]
b. 1867
8
Bertha Hopper
[1.2.1.4.7.6.4.5]
b. 1871
8
George Trafford Hopper
[1.2.1.4.7.6.4.6]
b. 1873 d. 24 Jun 1880
7
Job Trafford
[1.2.1.4.7.6.5]
b. 1844 d. 1912
7
Ruth Maria Trafford
[1.2.1.4.7.6.6]
b. 2 Dec 1848 d. 22 Jun 1929
William James Ruby
b. 1849
8
William John Ruby
[1.2.1.4.7.6.6.1]
b. 1868
8
James Henry Ruby
[1.2.1.4.7.6.6.2]
b. 1869
8
Beatrice Phoebe Ruby
[1.2.1.4.7.6.6.3]
b. 1872
8
Alfred Ruby
[1.2.1.4.7.6.6.4]
b. 1874
8
Bertha Ruby
[1.2.1.4.7.6.6.5]
b. 1876
8
Jesse Ruby
[1.2.1.4.7.6.6.6]
b. 1879
8
Bessie Ruby
[1.2.1.4.7.6.6.7]
b. 1882
8
George Ruby
[1.2.1.4.7.6.6.8]
b. 1886
8
Frederick Napier Ruby
[1.2.1.4.7.6.6.9]
b. 1889
8
Clarice Napier Ruby
[1.2.1.4.7.6.6.10]
b. 6 Apr 1891
+
Hector MacDonald
b. 1890 d. 1916
6
Henry Trafford
[1.2.1.4.7.7]
c. 3 Sep 1809 d. 10 Mar 1833
+
Charlotte Blanchett
b. 1811
5
Susanna Trafford
[1.2.1.4.8]
b. 28 Sep 1766
5
Henry Trafford
[1.2.1.4.9]
b. 2 Jul 1769 d. 27 Dec 1829
Martha Norris
b. 1772
6
Jane Trafford
[1.2.1.4.9.1]
b. 1 Oct 1803
6
Sarah Trafford
[1.2.1.4.9.2]
c. 3 Aug 1806 d. 27 Apr 1842
John Currell
b. 1799 d. 1868
7
Henry Currell
[1.2.1.4.9.2.1]
b. 1825 d. 11 Sep 1825
7
Juliana Currell
[1.2.1.4.9.2.2]
c. 21 May 1826
7
Jane Norris Currell
[1.2.1.4.9.2.3]
c. 24 Feb 1828
7
Henry John Currell
[1.2.1.4.9.2.4]
c. 18 Apr 1830
Edith Goodgame
b. 1838
8
George H Currell
[1.2.1.4.9.2.4.1]
b. 1858 d. 1896
Mary Ann
b. 1858
9
Henry Currell
[1.2.1.4.9.2.4.1.1]
b. 1882
9
Charles Currell
[1.2.1.4.9.2.4.1.2]
b. 1884
9
George Frank Currell
[1.2.1.4.9.2.4.1.3]
b. 1887
9
Frederick William Currell
[1.2.1.4.9.2.4.1.4]
b. 1889 d. 1891
9
Edith Currell
[1.2.1.4.9.2.4.1.5]
b. 1891
8
Henry Alfred Currell
[1.2.1.4.9.2.4.2]
b. 1861
Mary
b. 1862
9
George Henry H Currell
[1.2.1.4.9.2.4.2.1]
b. 1885
9
Edith Beatrice Currell
[1.2.1.4.9.2.4.2.2]
b. 1887
9
Adelade J G Currell
[1.2.1.4.9.2.4.2.3]
b. 1889
7
John Norris Currell
[1.2.1.4.9.2.5]
c. 4 Mar 1832
7
Sarah Currell
[1.2.1.4.9.2.6]
c. 7 Sep 1834
7
William Currell
[1.2.1.4.9.2.7]
c. 17 Jan 1837
7
Martha Currell
[1.2.1.4.9.2.8]
c. 13 Nov 1839
6
Martha Trafford
[1.2.1.4.9.3]
c. 11 Sep 1808
William Kimber
b. 1804
7
Martha Kimber
[1.2.1.4.9.3.1]
c. 8 Mar 1830
7
William Kimber
[1.2.1.4.9.3.2]
c. 9 Oct 1831
7
Jane Kimber
[1.2.1.4.9.3.3]
c. 5 May 1834
7
Willoughby Kimber
[1.2.1.4.9.3.4]
c. 24 Apr 1836
7
Henry Kimber
[1.2.1.4.9.3.5]
b. 1840
Elizabeth
b. 1838
8
Ada Martha Kimber
[1.2.1.4.9.3.5.1]
b. 1870
7
Mary Kimber
[1.2.1.4.9.3.6]
b. 1840
7
Arabella Kimber
[1.2.1.4.9.3.7]
b. 1842
7
Sarah Kimber
[1.2.1.4.9.3.8]
b. 1843
7
Elias Kimber
[1.2.1.4.9.3.9]
b. 1847
Caroline Higgins
b. 1846
8
Louisa Caroline Kimber
[1.2.1.4.9.3.9.1]
b. 1870
8
William Kimber
[1.2.1.4.9.3.9.2]
b. 1872
8
Claire Kimber
[1.2.1.4.9.3.9.3]
b. 1873
8
Arabella Emily Kimber
[1.2.1.4.9.3.9.4]
b. 1875
8
Henry Kimber
[1.2.1.4.9.3.9.5]
b. 1876
8
Augusta Martha Kimber
[1.2.1.4.9.3.9.6]
b. 1878
+
William Harry Townsend
b. 1880
8
Thomas Kimber
[1.2.1.4.9.3.9.7]
b. 1879
8
Anthony Kimber
[1.2.1.4.9.3.9.8]
b. 1881
+
Miriam Charlotte Coppock
b. 1882 d. Mar 1915
8
Frederick Kimber
[1.2.1.4.9.3.9.9]
b. 1882
8
Adelaide Margaret Kimber
[1.2.1.4.9.3.9.10]
b. 1886
8
Beatrice Mary Kimber
[1.2.1.4.9.3.9.11]
b. 1888
7
William Kimber
[1.2.1.4.9.3.10]
b. 1849
7
Jane Kimber
[1.2.1.4.9.3.11]
b. 1851
6
Mary Ann Trafford
[1.2.1.4.9.4]
c. 4 Jul 1813
6
Henry Trafford
[1.2.1.4.9.5]
b. 1816
6
Jacob Trafford
[1.2.1.4.9.6]
c. 10 Oct 1802 bur. 2 Mar 1854
Elizabeth Blanchett
b. Abt 1802
7
Mary Ann Trafford
[1.2.1.4.9.6.1]
b. 1836
7
Jacob Henry Trafford
[1.2.1.4.9.6.2]
b. 1839
Rhoda Morris
c. 26 Nov 1837
8
Willoughby Trafford
[1.2.1.4.9.6.2.1]
b. 1858
Sarah Ellen Emma Parsons
b. 1860
9
Ernest Christopher Trafford
[1.2.1.4.9.6.2.1.1]
c. 22 Jul 1884 d. 27 Mar 1961
9
Margaret Ellen Trafford
[1.2.1.4.9.6.2.1.2]
c. 15 Apr 1886
9
William Arthur Thomas Trafford
[1.2.1.4.9.6.2.1.3]
c. 18 Dec 1887 d. 25 Sep 1915
9
Lillian Bessie Trafford
[1.2.1.4.9.6.2.1.4]
c. 27 Apr 1890 bur. 13 Aug 1890
9
Annie Elizabeth Trafford
[1.2.1.4.9.6.2.1.5]
c. 16 Feb 1892 bur. 27 Mar 1892
9
Arthur Trafford
[1.2.1.4.9.6.2.1.6]
c. 16 Feb 1892 bur. 22 Feb 1892
8
Aubrey Charles Trafford
[1.2.1.4.9.6.2.2]
b. 1861
8
Ernest Arthur Trafford
[1.2.1.4.9.6.2.3]
b. 1863 bur. 4 Mar 1917
8
Elizabeth Mary Trafford
[1.2.1.4.9.6.2.4]
b. 1866 bur. 9 Mar 1938
8
Henry Herbert Trafford
[1.2.1.4.9.6.2.5]
b. 1868 d. 27 Mar 1955
Edith Jane Duffield
b. Mar 1868 d. 1952
9
Edith Florence Trafford
[1.2.1.4.9.6.2.5.1]
b. 1895 d. 1895
9
Henry John Trafford
[1.2.1.4.9.6.2.5.2]
b. 3 Jun 1897 d. 1979
9
Nellie Victoria Alice Trafford
[1.2.1.4.9.6.2.5.3]
b. 5 Jun 1900 d. 28 Sep 1982
9
George Trafford
[1.2.1.4.9.6.2.5.4]
b. 1903 d. 1904
9
Frederick Trafford
[1.2.1.4.9.6.2.5.5]
b. 1905 d. 1907
8
Pamela Jane Trafford
[1.2.1.4.9.6.2.6]
b. Mar 1870
Frederick Coles
b. 1863
9
Alice Coles
[1.2.1.4.9.6.2.6.1]
b. 1896
9
Frank Coles
[1.2.1.4.9.6.2.6.2]
b. Oct 1900
8
Edward Trafford
[1.2.1.4.9.6.2.7]
b. 1874 d. 8 Dec 1958
Sarah Ellen Surman
b. Abt 1879 d. 8 Jan 1955
9
Ernest Arthur Trafford
[1.2.1.4.9.6.2.7.1]
b. 27 Nov 1898 d. 26 Dec 1963
9
Alice May Trafford
[1.2.1.4.9.6.2.7.2]
b. Abt 1902 d. 23 Apr 1960
+
Edward Woodbridge Hedges
b. Abt 1900 bur. Sep 1990
9
Ethel Annie Trafford
[1.2.1.4.9.6.2.7.3]
b. 8 Aug 1904 d. 6 Dec 1979
9
Evelyn Gladys Trafford
[1.2.1.4.9.6.2.7.4]
b. Jun 1909 d. 16 Nov 1997
8
Alice Mary Trafford
[1.2.1.4.9.6.2.8]
b. 1876
+
Goss
b. Abt 1874
8
George Percy Trafford
[1.2.1.4.9.6.2.9]
c. 14 Sep 1879 d. 11 Oct 1900
5
Jacob Trafford
[1.2.1.4.10]
b. 25 Oct 1772 d. 19 Jan 1781
3
Elizabeth Bushnell
[1.2.2]
c. 8 Aug 1697 d. 22 Aug 1697
3
Richard Bushnell
[1.2.3]
c. 10 Sep 1699 d. 17 Nov 1701
3
Thomas Bushnell
[1.2.4]
c. 17 Nov 1701 d. 18 Mar 1703
3
William Bushnell
[1.2.5]
c. 16 Jul 1704
Amy Shyllis
b. Abt 1707
4
William Bush
[1.2.5.1]
b. 2 Nov 1729
4
Elizabeth Bushnell
[1.2.5.2]
b. 5 Jan 1735
4
Ann Bush
[1.2.5.3]
b. 27 Jan 1739 d. 26 Feb 1810
4
Hannah Bush
[1.2.5.4]
b. 5 Sep 1742
3
Mary Bushnell
[1.2.6]
c. 20 May 1707
3
Robert Bushnell
[1.2.7]
c. 5 Aug 1711 d. 7 Oct 1711
3
Elizabeth Bushnell
[1.2.8]
c. 12 Jul 1713