Home Page
|
What's New
|
Photos
|
Histories
|
Headstones
|
Reports
|
Surnames
Search
First Name:
Last Name:
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Suomalainen
Svenska
Nicholas Wickersley
1482 - 1528 (46 years)
Submit Photo / Document
Individual
Descendants
Relationship
Timeline
Submit Photo / Doc
Worksheet
Family
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Nicholas Wickersley
[1]
b. 1482 d. 1528
Mrs Wickersley
b. 1488
2
Eleanor Wickersley
[1.1]
b. Abt 1509 d. 1532
Richard Swift
b. 1505 d. 3 Sep 1558
3
Thomas Swift
[1.1.1]
b. Abt 1525
3
Isabella Swift
[1.1.2]
b. 1531 d. 1557
John Boithes
b. 1525 d. 27 Mar 1569
4
Thomas Boithes
[1.1.2.1]
b. 1550
4
Isabella Boithes
[1.1.2.2]
b. 1552
4
Robert Boithes
[1.1.2.3]
b. 1552
4
Henry Boithes
[1.1.2.4]
c. 26 Jan 1555
4
Genet Boithes
[1.1.2.5]
c. 2 Jul 1555
4
Grace Boithes
[1.1.2.6]
c. 16 Jul 1557 d. 9 Mar 1628
Henry Best
b. 20 Apr 1554 d. Sep 1622
5
Michael Best
[1.1.2.6.1]
b. 14 Aug 1578
5
Judith Best
[1.1.2.6.2]
b. 12 Feb 1580
5
John Best
[1.1.2.6.3]
b. Abt 1584 d. 21 Jun 1654
Jane Robinsonne
b. 1587 d. 1607
6
Elizabeth Best
[1.1.2.6.3.1]
b. 1607 d. 27 Feb 1661
William Enos Hunt
b. 25 Jan 1604 d. 2 Oct 1677
7
Nehemiah Hunt
[1.1.2.6.3.1.1]
b. Jun 1631 d. 6 Mar 1717
Mary Toll
b. 8 Dec 1643 d. 29 Aug 1727
8
Mary Hunt
[1.1.2.6.3.1.1.1]
b. 28 Sep 1664 d. 1 Dec 1702
Thomas Wood
b. 10 Aug 1658 d. 1 Dec 1702
9
Mary Wood
[1.1.2.6.3.1.1.1.1]
b. 29 Aug 1684 d. 12 Dec 1774
Daniel Pearson
b. 25 Dec 1684 d. 8 Jun 1759
10
Simon Pearson
[1.1.2.6.3.1.1.1.1.1]
b. 7 Nov 1709
Ruth Taylor
b. 3 Apr 1712
11
Ruth Pearson
[1.1.2.6.3.1.1.1.1.1.1]
b. 21 Oct 1739
11
Benjamin Person
[1.1.2.6.3.1.1.1.1.1.2]
b. 21 May 1742
11
Ezra Pearson
[1.1.2.6.3.1.1.1.1.1.3]
b. 16 Apr 1744 d. 30 Dec 1800
Anne Fuller
b. 1741 d. Aft 1810
12
Lucinda Pearson
[1.1.2.6.3.1.1.1.1.1.3.1]
b. 29 Jan 1767
12
Lieutenant Adin Pearson
[1.1.2.6.3.1.1.1.1.1.3.2]
b. 28 Nov 1768 d. 7 Jun 1853 [
=>
]
12
Zelotes Pearson
[1.1.2.6.3.1.1.1.1.1.3.3]
b. 9 Sep 1771
12
Clarice Pearson
[1.1.2.6.3.1.1.1.1.1.3.4]
b. 11 Feb 1774
12
Jerusha Pearson
[1.1.2.6.3.1.1.1.1.1.3.5]
b. 15 Aug 1776 d. 9 Feb 1874
12
Anna Pearson
[1.1.2.6.3.1.1.1.1.1.3.6]
b. 2 Feb 1779 d. 26 Jan 1830 [
=>
]
10
Ephraim Pearson
[1.1.2.6.3.1.1.1.1.2]
c. 25 Nov 1711
James Dickinson
b. 30 Jun 1678 d. 5 Jan 1705
10
Mary Dickinson
[1.1.2.6.3.1.1.1.1.3]
b. 29 Nov 1703 d. 8 Jun 1759
10
James Dickinson
[1.1.2.6.3.1.1.1.1.4]
b. 31 Dec 1705 d. 27 Jun 1756
Ruth Hartshorn
b. 12 May 1706 d. Aft 1750
11
Mary Dickinson
[1.1.2.6.3.1.1.1.1.4.1]
b. 20 Feb 1728
11
Submit Dickinson
[1.1.2.6.3.1.1.1.1.4.2]
b. 29 Jun 1731 d. 1788
11
Ruth Dickson
[1.1.2.6.3.1.1.1.1.4.3]
b. 3 Mar 1734
11
James Dickinson
[1.1.2.6.3.1.1.1.1.4.4]
b. 1 Aug 1736 d. Aft 1775
11
Jonathan Dickinson
[1.1.2.6.3.1.1.1.1.4.5]
b. 18 Nov 1738 d. 16 Oct 1762
Abigail Whipple
b. 30 Jan 1729 d. 21 Apr 1806
12
Mary Dickinson
[1.1.2.6.3.1.1.1.1.4.5.1]
b. 25 Dec 1758 d. 5 Mar 1759
12
Jonathan Dickinson
[1.1.2.6.3.1.1.1.1.4.5.2]
b. 30 Sep 1760
12
Mary Dickinson
[1.1.2.6.3.1.1.1.1.4.5.3]
b. Mar 1762 d. May 1850
11
Noah Dickinson
[1.1.2.6.3.1.1.1.1.4.6]
b. 14 Mar 1741 d. 16 Jan 1828
11
Mathew Dickinson
[1.1.2.6.3.1.1.1.1.4.7]
b. 14 Apr 1743 d. 21 Sep 1762
11
Ruth Dickinson
[1.1.2.6.3.1.1.1.1.4.8]
b. 29 Jul 1745 d. 22 Nov 1834
11
Love Dickinson
[1.1.2.6.3.1.1.1.1.4.9]
b. 2 Jun 1750
9
Thomas Wood
[1.1.2.6.3.1.1.1.2]
b. 18 Sep 1686 d. 27 Sep 1760
Abigail Hartshorn
b. 29 Sep 1686 d. 22 Sep 1760
10
Thomas Wood
[1.1.2.6.3.1.1.1.2.1]
b. 5 Feb 1711 d. 1777
Mary Lashley
b. 25 Mar 1711 d. Abt Dec 1809
11
John Wood
[1.1.2.6.3.1.1.1.2.1.1]
b. 13 Sep 1733
11
Elizabeth Wood
[1.1.2.6.3.1.1.1.2.1.2]
b. 20 Jul 1735 d. 1795
11
Johannah Wood
[1.1.2.6.3.1.1.1.2.1.3]
b. 22 Jun 1737 d. 3 Jun 1805
11
Alice Wood
[1.1.2.6.3.1.1.1.2.1.4]
b. 1738
11
Elijah Wood
[1.1.2.6.3.1.1.1.2.1.5]
b. 1739 d. Feb 1805
11
Lashley Levi Wood
[1.1.2.6.3.1.1.1.2.1.6]
b. 1740 d. 15 Aug 1809
Mary Mersey Lucas
b. Jan 1740 d. 1809
12
Mary Wood
[1.1.2.6.3.1.1.1.2.1.6.1]
c. 8 Apr 1764 d. 1840 [
=>
]
12
Leatha Ann Wood
[1.1.2.6.3.1.1.1.2.1.6.2]
b. 10 Aug 1766 d. 1831
12
John Wood
[1.1.2.6.3.1.1.1.2.1.6.3]
b. 10 Aug 1768 d. 15 Sep 1853
12
Basil Wood
[1.1.2.6.3.1.1.1.2.1.6.4]
b. 1770 d. 20 Jul 1841
12
Casey Wood
[1.1.2.6.3.1.1.1.2.1.6.5]
b. 1772
12
Elizabeth Wood
[1.1.2.6.3.1.1.1.2.1.6.6]
b. 1780
12
Thomas Wood
[1.1.2.6.3.1.1.1.2.1.6.7]
b. 1782 d. 1820
11
Thomas Wood
[1.1.2.6.3.1.1.1.2.1.7]
b. 1740
11
Robert Wood
[1.1.2.6.3.1.1.1.2.1.8]
b. 1741
10
Mary Wood
[1.1.2.6.3.1.1.1.2.2]
b. 3 Nov 1712 d. 1 Aug 1727
10
John Wood
[1.1.2.6.3.1.1.1.2.3]
b. 4 Apr 1715 d. 11 Aug 1775
10
Ruth Wood
[1.1.2.6.3.1.1.1.2.4]
b. 24 Oct 1718
10
Martha Wood
[1.1.2.6.3.1.1.1.2.5]
b. 17 Feb 1722
10
Ephraim Wood
[1.1.2.6.3.1.1.1.2.6]
b. 18 Jun 1723 d. 1746
10
Dinah Wood
[1.1.2.6.3.1.1.1.2.7]
b. 17 Jun 1725
10
Nehemiah Wood
[1.1.2.6.3.1.1.1.2.8]
b. 16 Jan 1727 d. 1796
10
Jonathan Wood
[1.1.2.6.3.1.1.1.2.9]
b. 16 May 1730
9
Nehemiah Wood
[1.1.2.6.3.1.1.1.3]
b. 14 Jul 1688 d. 4 Aug 1688
9
Ephraim Wood
[1.1.2.6.3.1.1.1.4]
b. 13 Oct 1689 d. 26 Jun 1713
9
Samuel Wood
[1.1.2.6.3.1.1.1.5]
b. 31 May 1692 d. 25 Jul 1742
+
Jane Dudley
c. 1693
9
Elizabeth Wood
[1.1.2.6.3.1.1.1.6]
b. 8 Apr 1694 d. 23 Jul 1731
+
Philip Turner
9
Mehitable Wood
[1.1.2.6.3.1.1.1.7]
b. 18 Dec 1695 d. 26 Oct 1758
James Hall
b. 1693 d. 16 Jan 1742
10
Mary Hall
[1.1.2.6.3.1.1.1.7.1]
b. 27 Sep 1717 d. 1778
10
James Hall
[1.1.2.6.3.1.1.1.7.2]
b. 20 Apr 1720 d. 2 Feb 1807
10
Mehetable Hall
[1.1.2.6.3.1.1.1.7.3]
b. 18 Feb 1722 d. 7 Dec 1803
10
Elizabeth Hall
[1.1.2.6.3.1.1.1.7.4]
b. 18 Apr 1723
10
Jane Hall
[1.1.2.6.3.1.1.1.7.5]
b. 5 Mar 1725
10
William Hall
[1.1.2.6.3.1.1.1.7.6]
b. 12 Jul 1728
10
Thomas Hall
[1.1.2.6.3.1.1.1.7.7]
b. 14 Jun 1730
10
Ephraim Hall
[1.1.2.6.3.1.1.1.7.8]
b. 21 Sep 1732 d. 29 Sep 1816
10
Gershom Hall
[1.1.2.6.3.1.1.1.7.9]
b. 25 Feb 1735
10
Josiah Hall
[1.1.2.6.3.1.1.1.7.10]
b. 27 Mar 1738 d. 1810
9
Ann Wood
[1.1.2.6.3.1.1.1.8]
b. 11 Apr 1700 d. 30 Jul 1793
Isaac Sargent
b. Abt 24 Feb 1695 d. 12 Apr 1742
10
John Sargent
[1.1.2.6.3.1.1.1.8.1]
b. 6 Mar 1722 d. Dec 1827
10
Mary Sargent
[1.1.2.6.3.1.1.1.8.2]
b. 22 Apr 1725 d. 12 Dec 1740
10
Ana Sargent
[1.1.2.6.3.1.1.1.8.3]
b. 23 Feb 1727 d. 8 May 1821
10
Isaac Sargent
[1.1.2.6.3.1.1.1.8.4]
b. 30 Dec 1728 d. 17 Dec 1729
10
Hannah Sargent
[1.1.2.6.3.1.1.1.8.5]
b. 3 Dec 1730 d. 14 Aug 1751
10
Ruth Sargent
[1.1.2.6.3.1.1.1.8.6]
b. 14 Oct 1732 d. 29 Aug 1808
10
Elizabeth Sargent
[1.1.2.6.3.1.1.1.8.7]
b. 5 Feb 1734 d. 28 Dec 1776
10
Deborah Sargent
[1.1.2.6.3.1.1.1.8.8]
b. 2 Feb 1736 d. 1833
10
Isaac Sargent
[1.1.2.6.3.1.1.1.8.9]
b. 8 Dec 1737 d. Jan 1813
9
Hannah Wood
[1.1.2.6.3.1.1.1.9]
b. 21 May 1703 d. 18 Mar 1764
8
John Hunt
[1.1.2.6.3.1.1.2]
b. 1667 d. 10 Jun 1669
8
Nehemiah Hunt
[1.1.2.6.3.1.1.3]
b. 29 Sep 1669 d. 27 Oct 1718
8
John Hunt
[1.1.2.6.3.1.1.4]
b. 12 Jan 1673 d. 26 Dec 1751
8
William Hunt
[1.1.2.6.3.1.1.5]
b. 1 Nov 1678 d. 12 May 1755
8
Mercy Hunt
[1.1.2.6.3.1.1.6]
b. 29 Nov 1676 d. 28 Nov 1733
8
Hannah Hunt
[1.1.2.6.3.1.1.7]
b. 24 Jan 1681 d. 2 Aug 1736
8
Simon Hunt
[1.1.2.6.3.1.1.8]
b. 7 Mar 1682 d. 7 Oct 1702
8
Rebecca Hunt
[1.1.2.6.3.1.1.9]
b. 1686 d. 28 Nov 1733
8
Elizabeth Hunt
[1.1.2.6.3.1.1.10]
b. 3 Jun 1687 d. 13 Jul 1767
7
Samuel Hunt
[1.1.2.6.3.1.2]
b. 1633 d. 1707
Elizabeth Redding
b. 1634 d. 16 Feb 1706
8
Samuel Hunt
[1.1.2.6.3.1.2.1]
b. 17 Nov 1657 d. 11 Jan 1742
Ruth Todd
b. 11 Feb 1657 d. 18 Feb 1716
9
Samuel Hunt
[1.1.2.6.3.1.2.1.1]
b. 4 Feb 1678 d. 13 Oct 1738
Sarah Stearns
b. 21 Mar 1681 d. 10 Sep 1708
10
Sarah Hunt
[1.1.2.6.3.1.2.1.1.1]
b. 22 Oct 1702 d. 26 Jan 1750
10
Mary Hunt
[1.1.2.6.3.1.2.1.1.2]
b. 12 Jan 1705 d. 11 May 1796
Anne Haseltine
b. 4 Aug 1677 d. 16 Jul 1757
10
Thomas Hunt
[1.1.2.6.3.1.2.1.1.3]
b. 2 Aug 1710 d. Nov 1710
10
Samuel Hunt
[1.1.2.6.3.1.2.1.1.4]
b. 26 Sep 1711 d. Jan 1806
Hannah Kimball
b. 14 Apr 1723 d. 25 May 1776
11
Samuel Hunt
[1.1.2.6.3.1.2.1.1.4.1]
b. 19 Dec 1741 d. 1 Apr 1742
11
Samuel Hunt
[1.1.2.6.3.1.2.1.1.4.2]
b. 20 Sep 1743 d. 29 Apr 1766
11
Hannah Hunt
[1.1.2.6.3.1.2.1.1.4.3]
b. 3 Jan 1746 d. 9 Dec 1749
11
Johathan Hunt
[1.1.2.6.3.1.2.1.1.4.4]
b. 2 Jul 1750
11
Martha Hunt
[1.1.2.6.3.1.2.1.1.4.5]
b. 2 Apr 1758 d. 15 Feb 1825
11
Ebenezer Hunt
[1.1.2.6.3.1.2.1.1.4.6]
b. 18 Apr 1760 d. 30 Sep 1776
11
Perley Hunt
[1.1.2.6.3.1.2.1.1.4.7]
b. 23 Nov 1762 d. 21 Jun 1828
Persis Gleason
b. Sep 1766 d. 27 May 1835
12
Ebenezer
[1.1.2.6.3.1.2.1.1.4.7.1]
b. 23 Jun 1785 d. 24 Nov 1817
12
Elijah Hunt
[1.1.2.6.3.1.2.1.1.4.7.2]
b. 25 Apr 1787 d. 7 Sep 1860 [
=>
]
12
Anna Hunt
[1.1.2.6.3.1.2.1.1.4.7.3]
b. 15 Feb 1788 d. 18 Dec 1791
12
Persis Hunt
[1.1.2.6.3.1.2.1.1.4.7.4]
b. 20 May 1790
12
Amy Hunt
[1.1.2.6.3.1.2.1.1.4.7.5]
b. 1 Jul 1793 d. 26 Jul 1793
12
Perley Hunt
[1.1.2.6.3.1.2.1.1.4.7.6]
b. 5 Nov 1795 d. 18 Nov 1863
12
Kimball Hunt
[1.1.2.6.3.1.2.1.1.4.7.7]
b. 18 Feb 1797 d. Oct 1821
12
Anna Hunt
[1.1.2.6.3.1.2.1.1.4.7.8]
b. 20 Jun 1800
12
Samuel Hunt
[1.1.2.6.3.1.2.1.1.4.7.9]
b. 14 Jan 1803 d. 30 Sep 1846
12
Gratia Hunt
[1.1.2.6.3.1.2.1.1.4.7.10]
b. 25 Jun 1805 d. 20 Nov 1872
12
Charles Dickenson Hunt
[1.1.2.6.3.1.2.1.1.4.7.11]
b. 31 Jul 1807 d. Aft 1855
12
Fidelia Hunt
[1.1.2.6.3.1.2.1.1.4.7.12]
b. 1 Oct 1809 d. 25 Jan 1826
11
David Hunt
[1.1.2.6.3.1.2.1.1.4.8]
b. 3 Jun 1767 d. 4 Feb 1850
10
Ann Hunt
[1.1.2.6.3.1.2.1.1.5]
b. 8 Apr 1714 d. 1740
10
Mehitable Hunt
[1.1.2.6.3.1.2.1.1.6]
b. 9 Jul 1716 d. 3 Mar 1807
10
Susanna Hunt
[1.1.2.6.3.1.2.1.1.7]
b. 21 Feb 1717
10
David Hunt
[1.1.2.6.3.1.2.1.1.8]
b. 19 Nov 1719
10
Jonathan Hunt
[1.1.2.6.3.1.2.1.1.9]
b. 25 Feb 1722
9
John Hunt
[1.1.2.6.3.1.2.1.2]
b. 30 Dec 1680 d. 22 Jan 1740
9
Elizabeth Hunt
[1.1.2.6.3.1.2.1.3]
b. 4 Mar 1682 d. 13 Jul 1685
8
Elisabeth Hunt
[1.1.2.6.3.1.2.2]
b. 29 May 1661 d. 9 Jul 1689
Francis Palmer
b. 4 Dec 1657 d. 19 Apr 1733
9
Elizabeth Palmer
[1.1.2.6.3.1.2.2.1]
b. 20 Dec 1684 d. 17 Aug 1705
9
John Palmer
[1.1.2.6.3.1.2.2.2]
b. 21 Jun 1689 d. 20 May 1761
Mary Stickney
b. 1 Mar 1687 d. 2 Nov 1763
10
Elizabeth Palmer
[1.1.2.6.3.1.2.2.2.1]
b. 1 May 1710 d. 10 Jun 1782
10
Daniel Palmer
[1.1.2.6.3.1.2.2.2.2]
b. 31 Jul 1712 d. 1776
10
Jane Palmer
[1.1.2.6.3.1.2.2.2.3]
b. 24 Dec 1714 d. 2 Sep 1793
10
Mary Palmer
[1.1.2.6.3.1.2.2.2.4]
b. 1 Jun 1717 d. 2 Nov 1763
Moses Duty
b. 2 Sep 1700 d. 29 Dec 1763
11
Moses Duty
[1.1.2.6.3.1.2.2.2.4.1]
b. 9 Aug 1742 d. 27 May 1836
Ann Holland
b. 13 Dec 1730 d. 24 Jan 1782
12
Mehitabel Duty
[1.1.2.6.3.1.2.2.2.4.1.1]
b. 18 Jul 1762 d. 22 Mar 1826
12
Susa Duty
[1.1.2.6.3.1.2.2.2.4.1.2]
b. 9 Apr 1769
11
Mary Elizabeth Duty
[1.1.2.6.3.1.2.2.2.4.2]
b. 11 Oct 1743 d. 27 May 1836
Asael Smith
b. 7 Mar 1744 d. 31 Oct 1830
12
Jesse Smith
[1.1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.1]
b. 20 Apr 1768 d. 16 Mar 1793 [
=>
]
12
Priscilla Smith
[1.1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.2]
b. 21 Oct 1769 d. 17 Apr 1860 [
=>
]
12
Joseph Smith
[1.1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.3]
b. 12 Jul 1771 d. 14 Sep 1840 [
=>
]
12
Asahel Smith
[1.1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.4]
b. 21 May 1773 d. 21 Jul 1848 [
=>
]
12
Mary Smith
[1.1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.5]
b. 4 Jun 1775 d. 24 May 1844 [
=>
]
12
Samuel Smith
[1.1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.6]
b. 15 Sep 1777 d. 1 Apr 1830 [
=>
]
12
Silas Sanford Smith
[1.1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.7]
b. 1 Oct 1779 d. 13 Sep 1839 [
=>
]
12
Patriarch John Smith
[1.1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.8]
b. 16 Jul 1781 d. 23 May 1854 [
=>
]
12
Susannah Smith
[1.1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.9]
b. 18 May 1783 d. 22 Mar 1849
12
Stephen Smith
[1.1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.10]
b. 23 Apr 1785 d. 25 Jul 1802
12
Sarah Smith
[1.1.2.6.3.1.2.2.2.4.2.11]
b. 16 May 1789 d. 27 May 1824 [
=>
]
11
Eunice Duty
[1.1.2.6.3.1.2.2.2.4.3]
b. 20 Jun 1745 d. 27 May 1836
11
Mark Duty
[1.1.2.6.3.1.2.2.2.4.4]
b. 16 Oct 1747 d. 27 May 1836
Abigail Woodberry
b. 1 Apr 1746 d. 1774
12
Andrew Woodbarry Duty
[1.1.2.6.3.1.2.2.2.4.4.1]
b. 18 Jul 1772 d. 1823
12
Hannah Duty
[1.1.2.6.3.1.2.2.2.4.4.2]
b. 14 Dec 1773
12
Mark Duty
[1.1.2.6.3.1.2.2.2.4.4.3]
b. 16 Jun 1779 d. Abt 1855
12
Ebenezer Duty
[1.1.2.6.3.1.2.2.2.4.4.4]
b. 2 Jun 1782 d. 7 Sep 1852
11
William Duty
[1.1.2.6.3.1.2.2.2.4.5]
b. 9 Jan 1749 d. 27 Sep 1812
Mary Rowell
b. 29 Apr 1750 d. 27 May 1836
12
Mary Duty
[1.1.2.6.3.1.2.2.2.4.5.1]
b. 7 Nov 1774
12
Phebe Dutey
[1.1.2.6.3.1.2.2.2.4.5.2]
b. 4 Apr 1778 d. 16 Apr 1852
12
Abagail Duty
[1.1.2.6.3.1.2.2.2.4.5.3]
b. 4 Dec 1779
12
William Duty
[1.1.2.6.3.1.2.2.2.4.5.4]
b. 4 Jun 1781
12
Hannah Duty
[1.1.2.6.3.1.2.2.2.4.5.5]
b. 13 May 1783 d. Oct 1787
12
Charles Carpenter Duty
[1.1.2.6.3.1.2.2.2.4.5.6]
b. 12 Feb 1785
12
Benjamin Rowell Duty
[1.1.2.6.3.1.2.2.2.4.5.7]
b. 15 Aug 1787
12
Nathaniel Peabody Duty
[1.1.2.6.3.1.2.2.2.4.5.8]
b. 11 Aug 1789
11
Elizabeth Duty
[1.1.2.6.3.1.2.2.2.4.6]
b. 26 Oct 1751
11
Sarah Duty
[1.1.2.6.3.1.2.2.2.4.7]
b. 25 Jul 1753 d. 21 Dec 1767
11
Hannah Duty
[1.1.2.6.3.1.2.2.2.4.8]
b. 11 Jun 1755 d. 27 May 1836
William Rowell
b. 1749 d. 30 Mar 1844
12
Sarah Rowell
[1.1.2.6.3.1.2.2.2.4.8.1]
b. 4 Jul 1777
12
Moses Duty Rowell
[1.1.2.6.3.1.2.2.2.4.8.2]
b. 5 Oct 1778 d. 16 Nov 1857
12
John Sullivan Rowell
[1.1.2.6.3.1.2.2.2.4.8.3]
b. 1779 d. Abt 1824
12
Lavina Rowell
[1.1.2.6.3.1.2.2.2.4.8.4]
b. 1782 d. 11 Jan 1877
12
Elsie Alice Rowell
[1.1.2.6.3.1.2.2.2.4.8.5]
b. Abt 1786
12
Caleb Rowell
[1.1.2.6.3.1.2.2.2.4.8.6]
b. Abt 1788 d. 5 Apr 1835
12
Isaiah Rowell
[1.1.2.6.3.1.2.2.2.4.8.7]
b. Abt 1792 d. 25 Jun 1847
12
George Rowell
[1.1.2.6.3.1.2.2.2.4.8.8]
b. 16 Oct 1794 d. 21 Jan 1873
10
Hannah Palmer
[1.1.2.6.3.1.2.2.2.5]
b. 30 Sep 1719 d. 9 Mar 1792
Gideon Walker
b. 1715
11
Temperance Walker
[1.1.2.6.3.1.2.2.2.5.1]
b. Abt 1739
11
Eliphalet Walker
[1.1.2.6.3.1.2.2.2.5.2]
b. 3 Sep 1747 d. 28 Mar 1824
11
Mehitable Walker
[1.1.2.6.3.1.2.2.2.5.3]
b. Abt 1749
10
Mehitable Palmer
[1.1.2.6.3.1.2.2.2.6]
b. 18 Mar 1727 d. Bef Nov 1763
10
John Palmer
[1.1.2.6.3.1.2.2.2.7]
b. 30 Nov 1729 d. 6 Jan 1807
8
William Hunt
[1.1.2.6.3.1.2.3]
b. 23 Apr 1663 d. 12 Dec 1747
8
Joseph Hunt
[1.1.2.6.3.1.2.4]
b. 28 Oct 1665 d. 1757
8
Peter Hunt
[1.1.2.6.3.1.2.5]
b. 8 Aug 1668 d. 8 Mar 1669
7
Elizabeth Hunt
[1.1.2.6.3.1.3]
b. 1 Apr 1634 d. 18 Aug 1704
John Barron
b. 1635 d. 1 Jan 1693
8
Isaac Barron
[1.1.2.6.3.1.3.1]
b. Abt 1664
8
John Barron
[1.1.2.6.3.1.3.2]
b. 4 Apr 1665
8
Elizabeth Barron
[1.1.2.6.3.1.3.3]
b. 28 Sep 1667
8
Moses Barron
[1.1.2.6.3.1.3.4]
b. 26 Mar 1669 d. 1742
8
Elias Barron
[1.1.2.6.3.1.3.5]
b. 14 Jun 1672 d. 1725
8
Dorothy Barron
[1.1.2.6.3.1.3.6]
b. 6 Mar 1675
7
Ann Hunt
[1.1.2.6.3.1.4]
b. 17 May 1635 d. 29 Dec 1714
Thomas Wood
b. 7 Apr 1633 d. 21 Jul 1687
8
Mary Wood
[1.1.2.6.3.1.4.1]
b. 15 Mar 1654
James Chute
b. 1649 d. 1730
9
Mary Chute
[1.1.2.6.3.1.4.1.1]
b. 16 Sep 1674 d. 10 Sep 1750
9
Elisabeth Chute
[1.1.2.6.3.1.4.1.2]
b. 22 Jun 1676 d. 3 Apr 1761
9
Ann Chute
[1.1.2.6.3.1.4.1.3]
b. 9 Oct 1679 d. 1726
9
Lionel Chute
[1.1.2.6.3.1.4.1.4]
b. 15 Apr 1681 d. Aft 30 Apr 1730
9
James Chute
[1.1.2.6.3.1.4.1.5]
b. 14 Jun 1686 d. 31 Jan 1769
9
Thomas Chute
[1.1.2.6.3.1.4.1.6]
b. 30 Jan 1690 d. 1770
9
Martha Chute
[1.1.2.6.3.1.4.1.7]
b. 15 Feb 1693 d. 4 Jul 1777
9
Ruth Chute
[1.1.2.6.3.1.4.1.8]
b. 2 Nov 1695 d. 30 Apr 1776
9
Hannah Chute
[1.1.2.6.3.1.4.1.9]
b. 8 Jul 1700 d. 1787
8
John Wood
[1.1.2.6.3.1.4.2]
b. 2 Mar 1656 d. 24 Jun 1735
Isabella Hazen
b. 21 May 1662 d. 24 Jul 1735
9
Hannah Wood
[1.1.2.6.3.1.4.2.1]
b. 12 Jan 1681 d. 3 Mar 1733
9
John Wood
[1.1.2.6.3.1.4.2.2]
b. 13 Feb 1683 d. 13 Feb 1735
9
Priscillia Wood
[1.1.2.6.3.1.4.2.3]
b. 27 Aug 1686 d. 22 May 1721
9
Edward Wood
[1.1.2.6.3.1.4.2.4]
b. 7 Sep 1689 d. Bef 1704
9
Thomas Wood
[1.1.2.6.3.1.4.2.5]
b. 28 Nov 1691 d. 1764
9
Samuel Wood
[1.1.2.6.3.1.4.2.6]
b. 31 May 1692 d. 25 Jul 1742
9
Joseph Wood
[1.1.2.6.3.1.4.2.7]
b. 5 May 1696 d. 7 Feb 1766
9
Ebenezer Wood
[1.1.2.6.3.1.4.2.8]
b. 18 Sep 1698 d. 18 Jul 1744
9
Abigail Annie Wood
[1.1.2.6.3.1.4.2.9]
b. 17 Dec 1700 d. 4 Apr 1776
9
Richard Wood
[1.1.2.6.3.1.4.2.10]
b. 30 Jan 1706 d. 3 Jul 1761
9
Josiah Wood
[1.1.2.6.3.1.4.2.11]
b. 5 Apr 1708 d. Nov 1767
8
Thomas Wood
[1.1.2.6.3.1.4.3]
b. 10 Aug 1658 d. 1 Dec 1702
Mary Hunt
b. 28 Sep 1664 d. 1 Dec 1702
9
Mary Wood
[1.1.2.6.3.1.4.3.1]
b. 29 Aug 1684 d. 12 Dec 1774
Daniel Pearson
b. 25 Dec 1684 d. 8 Jun 1759
10
Simon Pearson
[1.1.2.6.3.1.4.3.1.1]
b. 7 Nov 1709
Ruth Taylor
b. 3 Apr 1712
11
Ruth Pearson
[1.1.2.6.3.1.4.3.1.1.1]
b. 21 Oct 1739
11
Benjamin Person
[1.1.2.6.3.1.4.3.1.1.2]
b. 21 May 1742
11
Ezra Pearson
[1.1.2.6.3.1.4.3.1.1.3]
b. 16 Apr 1744 d. 30 Dec 1800
Anne Fuller
b. 1741 d. Aft 1810
12
Lucinda Pearson
[1.1.2.6.3.1.4.3.1.1.3.1]
b. 29 Jan 1767
12
Lieutenant Adin Pearson
[1.1.2.6.3.1.4.3.1.1.3.2]
b. 28 Nov 1768 d. 7 Jun 1853 [
=>
]
12
Zelotes Pearson
[1.1.2.6.3.1.4.3.1.1.3.3]
b. 9 Sep 1771
12
Clarice Pearson
[1.1.2.6.3.1.4.3.1.1.3.4]
b. 11 Feb 1774
12
Jerusha Pearson
[1.1.2.6.3.1.4.3.1.1.3.5]
b. 15 Aug 1776 d. 9 Feb 1874
12
Anna Pearson
[1.1.2.6.3.1.4.3.1.1.3.6]
b. 2 Feb 1779 d. 26 Jan 1830 [
=>
]
10
Ephraim Pearson
[1.1.2.6.3.1.4.3.1.2]
c. 25 Nov 1711
James Dickinson
b. 30 Jun 1678 d. 5 Jan 1705
10
Mary Dickinson
[1.1.2.6.3.1.4.3.1.3]
b. 29 Nov 1703 d. 8 Jun 1759
10
James Dickinson
[1.1.2.6.3.1.4.3.1.4]
b. 31 Dec 1705 d. 27 Jun 1756
Ruth Hartshorn
b. 12 May 1706 d. Aft 1750
11
Mary Dickinson
[1.1.2.6.3.1.4.3.1.4.1]
b. 20 Feb 1728
11
Submit Dickinson
[1.1.2.6.3.1.4.3.1.4.2]
b. 29 Jun 1731 d. 1788
11
Ruth Dickson
[1.1.2.6.3.1.4.3.1.4.3]
b. 3 Mar 1734
11
James Dickinson
[1.1.2.6.3.1.4.3.1.4.4]
b. 1 Aug 1736 d. Aft 1775
11
Jonathan Dickinson
[1.1.2.6.3.1.4.3.1.4.5]
b. 18 Nov 1738 d. 16 Oct 1762
Abigail Whipple
b. 30 Jan 1729 d. 21 Apr 1806
12
Mary Dickinson
[1.1.2.6.3.1.4.3.1.4.5.1]
b. 25 Dec 1758 d. 5 Mar 1759
12
Jonathan Dickinson
[1.1.2.6.3.1.4.3.1.4.5.2]
b. 30 Sep 1760
12
Mary Dickinson
[1.1.2.6.3.1.4.3.1.4.5.3]
b. Mar 1762 d. May 1850
11
Noah Dickinson
[1.1.2.6.3.1.4.3.1.4.6]
b. 14 Mar 1741 d. 16 Jan 1828
11
Mathew Dickinson
[1.1.2.6.3.1.4.3.1.4.7]
b. 14 Apr 1743 d. 21 Sep 1762
11
Ruth Dickinson
[1.1.2.6.3.1.4.3.1.4.8]
b. 29 Jul 1745 d. 22 Nov 1834
11
Love Dickinson
[1.1.2.6.3.1.4.3.1.4.9]
b. 2 Jun 1750
9
Thomas Wood
[1.1.2.6.3.1.4.3.2]
b. 18 Sep 1686 d. 27 Sep 1760
Abigail Hartshorn
b. 29 Sep 1686 d. 22 Sep 1760
10
Thomas Wood
[1.1.2.6.3.1.4.3.2.1]
b. 5 Feb 1711 d. 1777
Mary Lashley
b. 25 Mar 1711 d. Abt Dec 1809
11
John Wood
[1.1.2.6.3.1.4.3.2.1.1]
b. 13 Sep 1733
11
Elizabeth Wood
[1.1.2.6.3.1.4.3.2.1.2]
b. 20 Jul 1735 d. 1795
11
Johannah Wood
[1.1.2.6.3.1.4.3.2.1.3]
b. 22 Jun 1737 d. 3 Jun 1805
11
Alice Wood
[1.1.2.6.3.1.4.3.2.1.4]
b. 1738
11
Elijah Wood
[1.1.2.6.3.1.4.3.2.1.5]
b. 1739 d. Feb 1805
11
Lashley Levi Wood
[1.1.2.6.3.1.4.3.2.1.6]
b. 1740 d. 15 Aug 1809
Mary Mersey Lucas
b. Jan 1740 d. 1809
12
Mary Wood
[1.1.2.6.3.1.4.3.2.1.6.1]
c. 8 Apr 1764 d. 1840 [
=>
]
12
Leatha Ann Wood
[1.1.2.6.3.1.4.3.2.1.6.2]
b. 10 Aug 1766 d. 1831
12
John Wood
[1.1.2.6.3.1.4.3.2.1.6.3]
b. 10 Aug 1768 d. 15 Sep 1853
12
Basil Wood
[1.1.2.6.3.1.4.3.2.1.6.4]
b. 1770 d. 20 Jul 1841
12
Casey Wood
[1.1.2.6.3.1.4.3.2.1.6.5]
b. 1772
12
Elizabeth Wood
[1.1.2.6.3.1.4.3.2.1.6.6]
b. 1780
12
Thomas Wood
[1.1.2.6.3.1.4.3.2.1.6.7]
b. 1782 d. 1820
11
Thomas Wood
[1.1.2.6.3.1.4.3.2.1.7]
b. 1740
11
Robert Wood
[1.1.2.6.3.1.4.3.2.1.8]
b. 1741
10
Mary Wood
[1.1.2.6.3.1.4.3.2.2]
b. 3 Nov 1712 d. 1 Aug 1727
10
John Wood
[1.1.2.6.3.1.4.3.2.3]
b. 4 Apr 1715 d. 11 Aug 1775
10
Ruth Wood
[1.1.2.6.3.1.4.3.2.4]
b. 24 Oct 1718
10
Martha Wood
[1.1.2.6.3.1.4.3.2.5]
b. 17 Feb 1722
10
Ephraim Wood
[1.1.2.6.3.1.4.3.2.6]
b. 18 Jun 1723 d. 1746
10
Dinah Wood
[1.1.2.6.3.1.4.3.2.7]
b. 17 Jun 1725
10
Nehemiah Wood
[1.1.2.6.3.1.4.3.2.8]
b. 16 Jan 1727 d. 1796
10
Jonathan Wood
[1.1.2.6.3.1.4.3.2.9]
b. 16 May 1730
9
Nehemiah Wood
[1.1.2.6.3.1.4.3.3]
b. 14 Jul 1688 d. 4 Aug 1688
9
Ephraim Wood
[1.1.2.6.3.1.4.3.4]
b. 13 Oct 1689 d. 26 Jun 1713
9
Samuel Wood
[1.1.2.6.3.1.4.3.5]
b. 31 May 1692 d. 25 Jul 1742
+
Jane Dudley
c. 1693
9
Elizabeth Wood
[1.1.2.6.3.1.4.3.6]
b. 8 Apr 1694 d. 23 Jul 1731
+
Philip Turner
9
Mehitable Wood
[1.1.2.6.3.1.4.3.7]
b. 18 Dec 1695 d. 26 Oct 1758
James Hall
b. 1693 d. 16 Jan 1742
10
Mary Hall
[1.1.2.6.3.1.4.3.7.1]
b. 27 Sep 1717 d. 1778
10
James Hall
[1.1.2.6.3.1.4.3.7.2]
b. 20 Apr 1720 d. 2 Feb 1807
10
Mehetable Hall
[1.1.2.6.3.1.4.3.7.3]
b. 18 Feb 1722 d. 7 Dec 1803
10
Elizabeth Hall
[1.1.2.6.3.1.4.3.7.4]
b. 18 Apr 1723
10
Jane Hall
[1.1.2.6.3.1.4.3.7.5]
b. 5 Mar 1725
10
William Hall
[1.1.2.6.3.1.4.3.7.6]
b. 12 Jul 1728
10
Thomas Hall
[1.1.2.6.3.1.4.3.7.7]
b. 14 Jun 1730
10
Ephraim Hall
[1.1.2.6.3.1.4.3.7.8]
b. 21 Sep 1732 d. 29 Sep 1816
10
Gershom Hall
[1.1.2.6.3.1.4.3.7.9]
b. 25 Feb 1735
10
Josiah Hall
[1.1.2.6.3.1.4.3.7.10]
b. 27 Mar 1738 d. 1810
9
Ann Wood
[1.1.2.6.3.1.4.3.8]
b. 11 Apr 1700 d. 30 Jul 1793
Isaac Sargent
b. Abt 24 Feb 1695 d. 12 Apr 1742
10
John Sargent
[1.1.2.6.3.1.4.3.8.1]
b. 6 Mar 1722 d. Dec 1827
10
Mary Sargent
[1.1.2.6.3.1.4.3.8.2]
b. 22 Apr 1725 d. 12 Dec 1740
10
Ana Sargent
[1.1.2.6.3.1.4.3.8.3]
b. 23 Feb 1727 d. 8 May 1821
10
Isaac Sargent
[1.1.2.6.3.1.4.3.8.4]
b. 30 Dec 1728 d. 17 Dec 1729
10
Hannah Sargent
[1.1.2.6.3.1.4.3.8.5]
b. 3 Dec 1730 d. 14 Aug 1751
10
Ruth Sargent
[1.1.2.6.3.1.4.3.8.6]
b. 14 Oct 1732 d. 29 Aug 1808
10
Elizabeth Sargent
[1.1.2.6.3.1.4.3.8.7]
b. 5 Feb 1734 d. 28 Dec 1776
10
Deborah Sargent
[1.1.2.6.3.1.4.3.8.8]
b. 2 Feb 1736 d. 1833
10
Isaac Sargent
[1.1.2.6.3.1.4.3.8.9]
b. 8 Dec 1737 d. Jan 1813
9
Hannah Wood
[1.1.2.6.3.1.4.3.9]
b. 21 May 1703 d. 18 Mar 1764
8
Ann Wood
[1.1.2.6.3.1.4.4]
b. 8 Aug 1660 d. 31 Jan 1715
Benjamin Plummer
b. 23 Oct 1656 d. 8 Jul 1724
9
John Plumer
[1.1.2.6.3.1.4.4.1]
b. 7 May 1680 d. 16 Apr 1706
9
Benjamin Plummer, Jr
[1.1.2.6.3.1.4.4.2]
b. 2 Mar 1681 d. 22 Jun 1734
9
Thomas Plummer
[1.1.2.6.3.1.4.4.3]
b. 15 Apr 1684 d. 15 Nov 1762
Ruth Pearson
b. 2 Aug 1687 d. 16 Nov 1736
10
Samuel Plumer
[1.1.2.6.3.1.4.4.3.1]
b. Abt 1726 d. 18 Jul 1807
10
Thomas Plumer
[1.1.2.6.3.1.4.4.3.2]
b. 1714 d. 12 Mar 1770
10
Ruth Plumer
[1.1.2.6.3.1.4.4.3.3]
b. 5 Feb 1721 d. 24 Jun 1736
10
Mehitabel Plumer
[1.1.2.6.3.1.4.4.3.4]
b. Bef 1712 d. Bef 27 Feb 1714
10
Stephen Plummer
[1.1.2.6.3.1.4.4.3.5]
b. 20 Feb 1716 d. Bef 1737
9
Sarah Plumer
[1.1.2.6.3.1.4.4.4]
b. 6 Aug 1686 d. Aft 1708
9
Stephen Palmer
[1.1.2.6.3.1.4.4.5]
b. 1 Sep 1688
9
Ann Plumer
[1.1.2.6.3.1.4.4.6]
b. 18 Jan 1690 d. 28 Jun 1748
9
Mary Plummer
[1.1.2.6.3.1.4.4.7]
b. 28 Jul 1694 d. 28 Jun 1748
9
Martha Plummer
[1.1.2.6.3.1.4.4.8]
b. 2 Mar 1696 d. 6 Aug 1733
9
Nathan Plummer
[1.1.2.6.3.1.4.4.9]
b. 26 Feb 1701 d. 1775
8
Ruth Wood
[1.1.2.6.3.1.4.5]
b. 21 May 1662 d. 29 Oct 1734
Joseph Jewett
b. 1 Apr 1656 d. 30 Oct 1694
9
Ruth Jewett
[1.1.2.6.3.1.4.5.1]
b. 1681 d. 28 Nov 1728
9
Joshua Jewett
[1.1.2.6.3.1.4.5.2]
b. 26 Aug 1683 d. 15 Oct 1694
9
Hannah Jewett
[1.1.2.6.3.1.4.5.3]
b. 3 Apr 1685 d. 23 Nov 1685
9
Elizabeth Jewett
[1.1.2.6.3.1.4.5.4]
b. 3 Apr 1685
9
Joseph Jewett
[1.1.2.6.3.1.4.5.5]
b. 10 Apr 1687 d. 10 Aug 1747
9
Sarah Jewett
[1.1.2.6.3.1.4.5.6]
b. 3 Feb 1689 d. 20 Nov 1722
9
Priscilla Jewett
[1.1.2.6.3.1.4.5.7]
b. 1 Feb 1690 d. 27 Dec 1722
Hilkiah Boynton
b. 19 Nov 1687 d. 16 Nov 1745
10
Joanna Boynton
[1.1.2.6.3.1.4.5.7.1]
b. 17 Aug 1712 d. Aft 7 Aug 1753
John Grout
b. 14 Oct 1704 d. Jun 1771
11
Johanna Grout
[1.1.2.6.3.1.4.5.7.1.1]
b. 8 Jan 1728/1729
11
Hilkiah Grout
[1.1.2.6.3.1.4.5.7.1.2]
b. 23 Jul 1728 d. 12 Dec 1795
11
John Grout, Jr
[1.1.2.6.3.1.4.5.7.1.3]
b. 13 Jun 1731 d. Aft 1779
Phebe Spofford
b. 1 Jul 1733
12
Phebe Grout
[1.1.2.6.3.1.4.5.7.1.3.1]
b. 21 Mar 1751 d. 1819 [
=>
]
12
Elijah Grout
[1.1.2.6.3.1.4.5.7.1.3.2]
b. 26 Jan 1753
12
Susannah Grout
[1.1.2.6.3.1.4.5.7.1.3.3]
b. 12 Dec 1754
12
Endymia Grout
[1.1.2.6.3.1.4.5.7.1.3.4]
b. 23 Dec 1756 d. 24 Apr 1759
12
Theodore Grout
[1.1.2.6.3.1.4.5.7.1.3.5]
b. 23 Aug 1759
12
Endymia Grout
[1.1.2.6.3.1.4.5.7.1.3.6]
b. 5 Aug 1761
12
John Butler Grout
[1.1.2.6.3.1.4.5.7.1.3.7]
b. 28 Apr 1763
12
Ferdinand Grout
[1.1.2.6.3.1.4.5.7.1.3.8]
b. 5 May 1765
12
Theodore Grout
[1.1.2.6.3.1.4.5.7.1.3.9]
b. 1 Feb 1767 d. 1831
12
Frederica Grout
[1.1.2.6.3.1.4.5.7.1.3.10]
b. 1 Dec 1768
12
Margaret Bradstreet Grout
[1.1.2.6.3.1.4.5.7.1.3.11]
b. 10 Apr 1771
11
Elijah Grout
[1.1.2.6.3.1.4.5.7.1.4]
b. 29 Oct 1732 d. Mar 1807
11
Joel Grout
[1.1.2.6.3.1.4.5.7.1.5]
b. 6 Mar 1734 d. 8 Sep 1797
11
Jonathan Grout
[1.1.2.6.3.1.4.5.7.1.6]
b. 23 Jul 1737 d. 8 Sep 1807
11
Sarah Grout
[1.1.2.6.3.1.4.5.7.1.7]
b. 28 Nov 1738 d. 21 Oct 1817
11
Patience Grout
[1.1.2.6.3.1.4.5.7.1.8]
b. 23 Aug 1740 d. 7 May 1810
11
Peter Grout
[1.1.2.6.3.1.4.5.7.1.9]
b. 9 Oct 1743
11
Abigail Grout
[1.1.2.6.3.1.4.5.7.1.10]
b. 23 Mar 1745 d. 14 Sep 1838
11
Josiah Grout
[1.1.2.6.3.1.4.5.7.1.11]
b. 28 Nov 1748 d. Bef 8 Jan 1777
11
Solomon Grout
[1.1.2.6.3.1.4.5.7.1.12]
b. 27 Jun 1751 d. 1787
11
Jehosaphat Grout
[1.1.2.6.3.1.4.5.7.1.13]
b. 7 Aug 1753 d. 6 Sep 1806
10
Priscilla Boynton
[1.1.2.6.3.1.4.5.7.2]
b. 11 Apr 1714 d. 1 Jan 1781
10
Hilikia Boynton
[1.1.2.6.3.1.4.5.7.3]
b. 11 Apr 1714 d. 28 Apr 1714
10
Joseph Boynton
[1.1.2.6.3.1.4.5.7.4]
b. 4 Dec 1717 d. 8 Feb 1718
10
Sarah Boynton
[1.1.2.6.3.1.4.5.7.5]
b. Abt 1718
10
Ruth Boynton
[1.1.2.6.3.1.4.5.7.6]
b. 1721 d. Jul 1721
10
Jane Boynton
[1.1.2.6.3.1.4.5.7.7]
b. 4 Mar 1722 d. 1743
9
Johanna Jewett
[1.1.2.6.3.1.4.5.8]
b. 12 Apr 1693 d. 26 Jul 1748
9
Joshua Jewett
[1.1.2.6.3.1.4.5.9]
b. 16 Feb 1695 d. 31 Oct 1760
8
Elizabeth Wood
[1.1.2.6.3.1.4.6]
b. 5 Sep 1664 d. Aft 1680
+
Captain Joseph Boynton
b. 13 May 1644 d. 16 Dec 1730
8
Josiah Wood
[1.1.2.6.3.1.4.7]
b. 5 Sep 1664 d. 10 Dec 1728
Mary Felt
b. Abt 1661 d. 4 Aug 1753
9
Samuel Wood
[1.1.2.6.3.1.4.7.1]
b. 4 Nov 1691
9
Sarah Wood
[1.1.2.6.3.1.4.7.2]
b. 15 Feb 1693 d. 10 Nov 1782
9
James Wood
[1.1.2.6.3.1.4.7.3]
b. 9 Apr 1695
9
Mary Wood
[1.1.2.6.3.1.4.7.4]
b. 28 Jan 1698 d. 3 Mar 1776
9
Josiah Wood
[1.1.2.6.3.1.4.7.5]
b. 14 Mar 1701 d. 7 Nov 1763
9
Ruth Wood
[1.1.2.6.3.1.4.7.6]
b. 4 Jun 1704
9
Elizabeth Wood
[1.1.2.6.3.1.4.7.7]
b. 26 May 1706 d. 1775
9
George Wood
[1.1.2.6.3.1.4.7.8]
b. 13 Aug 1708 d. Abt 1773
9
Anne Wood
[1.1.2.6.3.1.4.7.9]
b. 21 Dec 1710 d. 12 Nov 1783
9
Daniel David Wood
[1.1.2.6.3.1.4.7.10]
b. 13 Mar 1714 d. 16 May 1783
8
Samuel Wood
[1.1.2.6.3.1.4.8]
b. 26 Dec 1666 d. 25 Nov 1690
Margaret Elithorpe
b. 24 Jul 1672 d. 25 Jan 1754
9
Thomas Wood
[1.1.2.6.3.1.4.8.1]
b. 4 Mar 1689
8
Ebenezer Wood
[1.1.2.6.3.1.4.9]
b. 7 May 1669 d. 16 Feb 1737
+
Johanna Gage
b. Abt 1668 d. Aft 1737
8
Solomon Wood
[1.1.2.6.3.1.4.10]
b. 17 May 1669 d. 13 Jan 1752
8
James Wood
[1.1.2.6.3.1.4.11]
b. 22 Jun 1674 d. 18 Oct 1694
7
William Hunt
[1.1.2.6.3.1.5]
b. Abt 1635 d. 6 Sep 1694
7
Hannah Ann Hunt
[1.1.2.6.3.1.6]
b. 14 Feb 1640 d. 25 May 1721
Daniel White
b. Abt 1649 d. 6 May 1724
8
Joseph White
[1.1.2.6.3.1.6.1]
b. 17 Dec 1662 d. 28 Oct 1757
Susanna Sherman
b. Abt 1678 d. 22 Dec 1766
9
Hannah White
[1.1.2.6.3.1.6.1.1]
b. 28 Mar 1702 d. 29 Jul 1775
9
Abijah White
[1.1.2.6.3.1.6.1.2]
b. 8 Oct 1706 d. 20 Oct 1775
Anna Little
b. 30 Jan 1715 d. 11 Mar 1791
10
Anna White
[1.1.2.6.3.1.6.1.2.1]
b. 1739 d. Bef 1829
10
Persilla White
[1.1.2.6.3.1.6.1.2.2]
b. 1740 d. Bef 1830
10
Sylvanus White
[1.1.2.6.3.1.6.1.2.3]
b. 1742
10
Abijah White
[1.1.2.6.3.1.6.1.2.4]
b. 1745 d. 8 Feb 1746
10
Deborah White
[1.1.2.6.3.1.6.1.2.5]
b. 20 Aug 1746 d. 19 Oct 1746
10
Abijah White
[1.1.2.6.3.1.6.1.2.6]
b. 1747 d. 1777
10
Sarah White
[1.1.2.6.3.1.6.1.2.7]
b. 29 Mar 1749 d. Bef 1839
10
William White
[1.1.2.6.3.1.6.1.2.8]
b. Abt 1752 d. 19 Dec 1817
10
John White
[1.1.2.6.3.1.6.1.2.9]
b. 9 Sep 1753 d. 1 Feb 1774
10
Susanna White
[1.1.2.6.3.1.6.1.2.10]
b. 1756 d. 10 Apr 1793
10
Anna White
[1.1.2.6.3.1.6.1.2.11]
b. 27 Oct 1759
10
Persilla White
[1.1.2.6.3.1.6.1.2.12]
b. 17 Oct 1760
9
Cornelius White
[1.1.2.6.3.1.6.1.3]
b. 29 Jan 1711 d. 8 Nov 1800
Hannah Riggs
b. Abt 1670 d. Aft 1752
10
Prudence White
[1.1.2.6.3.1.6.1.3.1]
b. Abt 1741
10
Mose White
[1.1.2.6.3.1.6.1.3.2]
b. 2 Aug 1743 d. 6 Mar 1829
10
Sarah White
[1.1.2.6.3.1.6.1.3.3]
b. Abt 1748 d. Bef 1848
10
Mary White
[1.1.2.6.3.1.6.1.3.4]
b. Abt 1749 d. 10 Mar 1838
10
Hannah White
[1.1.2.6.3.1.6.1.3.5]
b. 1 Jan 1750
10
Asa White
[1.1.2.6.3.1.6.1.3.6]
b. 4 Aug 1752 d. 17 Jan 1822
9
Sarah White
[1.1.2.6.3.1.6.1.4]
b. 31 May 1710 d. 15 Feb 1788
Isaac Phillips
b. 5 Mar 1701 d. 18 Sep 1787
10
Isaac Phillips, Jr
[1.1.2.6.3.1.6.1.4.1]
b. 16 Dec 1728 d. 11 Jun 1831
10
David Phillips
[1.1.2.6.3.1.6.1.4.2]
b. 17 Aug 1731
10
Sarah Phillips
[1.1.2.6.3.1.6.1.4.3]
b. 4 Apr 1735 d. 26 Jul 1760
10
Anna Phillips
[1.1.2.6.3.1.6.1.4.4]
b. 15 Mar 1736 d. 19 Jan 1819
10
James Phillips
[1.1.2.6.3.1.6.1.4.5]
b. 30 Mar 1739
10
Rebekah Phillips
[1.1.2.6.3.1.6.1.4.6]
b. 21 Mar 1742
10
Joseph Phillips
[1.1.2.6.3.1.6.1.4.7]
b. 1 Dec 1749 d. 1751
10
Solomon Phillips
[1.1.2.6.3.1.6.1.4.8]
b. Dec 1750
9
Rebekah White
[1.1.2.6.3.1.6.1.5]
b. 17 Dec 1713 d. 1716
9
Sylvanus White
[1.1.2.6.3.1.6.1.6]
b. 24 Jul 1718 d. 19 Dec 1742
9
Jesse White
[1.1.2.6.3.1.6.1.7]
b. 7 Dec 1720 d. 1765
Catherina Charlotte Wilhelmina Subellina Warner
b. Abt 1720 d. Abt 1771
10
Sybelene White
[1.1.2.6.3.1.6.1.7.1]
b. 1744 d. May 1747
10
Sybelene White
[1.1.2.6.3.1.6.1.7.2]
b. 1748
10
Christiana White
[1.1.2.6.3.1.6.1.7.3]
b. 1750 d. 5 Aug 1818
Lydia Copeland
b. 27 Mar 1642 d. 8 May 1727
9
Mary White
[1.1.2.6.3.1.6.1.8]
b. 27 Feb 1682 d. 1701
9
Captain Joseph White
[1.1.2.6.3.1.6.1.9]
b. 19 Oct 1683 d. 15 Jun 1737
Prudence Smith
b. 19 Jul 1691 d. 5 Apr 1785
10
Joseph White
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.1]
b. 22 Sep 1712 d. 12 Mar 1788
Judeth Clarke
b. 1711 d. 3 Feb 1794
11
Sarah White
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.1.1]
b. 1735 d. 1747
11
Tryal White
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.1.2]
b. 8 May 1737 d. 14 Jun 1814
Lieutenant Abner Taft
b. 28 Dec 1736 d. 30 May 1809
12
Oliver Taft
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.1.2.1]
b. 1 May 1758 d. 16 Jul 1775
12
Moses Taft
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.1.2.2]
b. 29 Sep 1760 d. 4 Dec 1848 [
=>
]
12
Mary Taft
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.1.2.3]
b. 12 Oct 1767 d. 18 Aug 1775
12
Webb Taft
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.1.2.4]
b. 26 Mar 1772 d. 21 Apr 1842 [
=>
]
12
Trial T Taft
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.1.2.5]
b. 13 Apr 1777 d. 18 Aug 1815
11
Lois White
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.1.3]
b. 25 Aug 1739 d. 7 Jan 1806
Edward Seagrave
b. Abt 1722 d. 20 May 1793
12
John Seagrave
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.1.3.1]
b. 6 Nov 1757 d. 3 Feb 1842
12
Lois Seagrave
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.1.3.2]
b. 5 Nov 1759 d. 8 Mar 1819
12
Sarah Sally Seagrave
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.1.3.3]
b. 31 Dec 1760 d. 12 May 1851
12
Joseph Seagrave
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.1.3.4]
b. 21 Dec 1761 d. 30 Aug 1830
12
Mary Seagrave
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.1.3.5]
b. 1 Apr 1764 d. 1777
12
Bezaleel Seagrave
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.1.3.6]
b. 14 Dec 1766 d. 1 Aug 1830
12
Caleb Seagrave
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.1.3.7]
b. 14 Mar 1771 d. 22 Sep 1836
12
Josiah Seagrave
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.1.3.8]
b. 14 Oct 1773 d. 20 Mar 1855 [
=>
]
12
Edward Seagrave
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.1.3.9]
b. 14 Oct 1773 d. 31 Jul 1797
12
Olive Seagrave
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.1.3.10]
b. 17 Apr 1779 d. 1868
12
Samuel Seagraves
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.1.3.11]
b. 3 Feb 1782 d. 4 Feb 1855
11
Joseph White
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.1.4]
b. 1744 d. 1747
11
Judith White
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.1.5]
b. 1746 d. 1747
11
Amos White
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.1.6]
b. 1748 d. 1782
11
Joel White
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.1.7]
b. 1751 d. 1835
11
Jesse White
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.1.8]
b. 1754 d. 1830
11
Edward White
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.1.9]
b. 1756 d. 1756
11
Abner White
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.1.10]
b. 1758 d. 1758
11
Moses White
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.1.11]
b. 1759 d. 1759
11
Eunice White
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.1.12]
b. 1 Nov 1741 d. 3 Apr 1825
10
Peter White
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.2]
b. 6 Dec 1714 d. 8 May 1782
Jemima Taft
b. 1 Apr 1713 d. 14 Oct 1787
11
Joseph White
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.2.1]
b. 25 Jun 1738 d. 1805
11
Bethaih White
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.2.2]
b. 1 Mar 1740 d. 1809
11
Elisabeth White
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.2.3]
b. 13 Dec 1743
11
Peter White
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.2.4]
b. 1746 d. 2 Dec 1821
11
Jemima White
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.2.5]
b. Abt 1754 d. Abt 1782
11
Nathan White
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.2.6]
b. 10 Jan 1755 d. 21 Jan 1828
10
Aaron White
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.3]
b. 22 May 1717 d. Abt 1760
+
Susanah Benson
b. 2 Aug 1721 d. Aft 1750
10
Moses White
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.4]
b. 31 Aug 1721
Abigail Holbrook
b. Abt 1721 d. 1787
11
Stephen White
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.4.1]
b. 22 Sep 1754
11
Moses White
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.4.2]
b. 24 Jul 1751
11
Abner White
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.4.3]
b. 27 May 1753
10
Abigail White
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.5]
b. 27 Jan 1723 d. 4 May 1751
Benoni Benson
b. 18 Jul 1724 d. 10 Jan 1806
11
Stephen Benson
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.5.1]
b. 15 Jul 1742 d. 30 Jul 1823
Mary Holbrook
b. 15 Jul 1745 d. 1849
12
Ichabod Benson
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.5.1.1]
b. 30 Dec 1764 d. Aug 1794 [
=>
]
12
Elkanah Benson
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.5.1.2]
b. 21 Feb 1766 d. 8 Mar 1844 [
=>
]
12
Esther Benson
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.5.1.3]
b. 8 Dec 1768 d. 31 Mar 1855 [
=>
]
12
Ezekial Benson
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.5.1.4]
b. 13 Mar 1770
12
Phila Benson
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.5.1.5]
b. 23 Feb 1772 [
=>
]
12
Polly Benson
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.5.1.6]
b. 7 Nov 1773 [
=>
]
12
Sally Benson
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.5.1.7]
b. 13 Feb 1776 d. 24 Nov 1837 [
=>
]
11
Henry Benson
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.5.2]
b. 5 Dec 1743 d. 7 Dec 1777
Susanna Thayer
b. 23 Apr 1746 d. 4 Jan 1808
12
Hannah Benson
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.5.2.1]
b. 7 May 1764
12
Joanna Benson
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.5.2.2]
b. 6 Jul 1766 d. 29 Dec 1820 [
=>
]
12
Abigail Benson
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.5.2.3]
b. 2 Jul 1768
12
Henry Staples Benson
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.5.2.4]
b. 8 Aug 1770 d. 29 Jul 1821 [
=>
]
12
Tirza Benson
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.5.2.5]
b. 29 Apr 1772 [
=>
]
12
Susanna Thayer Benson
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.5.2.6]
b. 19 Feb 1775
12
Rachel Benson
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.5.2.7]
b. 5 May 1777 d. 21 Nov 1842 [
=>
]
11
Joanna Benson
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.5.3]
b. 14 Nov 1745 d. Bef 1806
11
Benoni Benson
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.5.4]
b. 11 Jul 1747 d. 1803
Ruth Holbrook
b. 10 Aug 1751 d. 16 May 1781
12
Amasa Benson
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.5.4.1]
b. 25 Jan 1771 d. 7 Mar 1837 [
=>
]
12
Chloe Benson
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.5.4.2]
b. 28 Jan 1774
12
Benoni Benson
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.5.4.3]
b. 1780 d. 1819
Ruth Sibley
b. 9 Apr 1745 d. 30 Nov 1814
12
John Benson
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.5.4.4]
b. 1789
11
John Benson
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.5.5]
b. 1 Aug 1749 d. 18 May 1818
Mary Holbrook
b. 1 Feb 1762 d. 27 Dec 1814
12
John Perry Benson
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.1]
b. 22 Jul 1781 d. 21 Jan 1842 [
=>
]
12
George Washington Benson
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.2]
b. 25 May 1783 d. 10 Nov 1855 [
=>
]
12
Jared Benson
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.3]
b. 3 Feb 1785 d. 31 Jul 1854 [
=>
]
12
Abigail Benson
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.4]
b. 13 Feb 1787 [
=>
]
12
Mary "Polly" Benson
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.5]
b. 9 Jun 1788 d. 12 Jan 1864 [
=>
]
12
Phyba Benson
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.6]
b. Abt 1790
12
Prudence Benson
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.7]
b. 7 Jul 1795
12
Thankful Benson
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.8]
b. 26 Nov 1799 d. 1 May 1852 [
=>
]
12
Sulvanus Holbrook Benson
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.9]
b. 12 Jan 1797 d. 24 Aug 1812
12
Judson Benson
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.10]
b. Abt 1801 d. 15 Oct 1813
Joanna Taft
b. 14 Nov 1751 d. 3 Oct 1777
12
Lovett Benson
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.11]
b. 6 Oct 1772 d. 4 Mar 1773
12
Lois Benson
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.12]
b. 17 Jul 1774 d. 10 Jul 1840 [
=>
]
12
Prudence Benson
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.5.5.13]
b. 4 May 1776 d. 16 May 1789
11
Ichabod Benson
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.5.6]
b. 4 May 1751 d. Bef 1806
10
Sarah White
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.6]
b. 8 Nov 1724
10
Ebenezer White
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.7]
b. 20 Nov 1726 d. 10 May 1812
Elizabeth Ellis
b. 10 Dec 1729
11
Ellis White
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.7.1]
b. 13 Oct 1748
11
Turner White
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.7.2]
b. Abt 1750 d. 6 Aug 1836
11
Abigail White
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.7.3]
b. 9 Sep 1752
11
Smith White
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.7.4]
b. 9 Oct 1755 d. 18 Apr 1823
11
Philadelphia White
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.7.5]
b. 6 Oct 1760
11
Melatiah White
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.7.6]
b. Abt 18 May 1766
11
Stephen White
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.7.7]
b. 11 May 1761 d. 20 Oct 1860
10
Prudence White
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.8]
b. 24 Sep 1729 d. Feb 1787
James Albee
b. 12 Mar 1721 d. 24 Nov 1795
11
Hope Albee
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.8.1]
b. Abt 1765 d. 18 Jan 1840
Stephen Holbrook
b. 19 Jun 1764 d. 16 Aug 1830
12
Rachel Holbrook
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.8.1.1]
b. 22 Apr 1789
12
Sylvanus Holbrook
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.8.1.2]
b. 28 Jul 1792 d. 9 Dec 1855
12
Willard Holbrook
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.8.1.3]
b. 7 Apr 1795 d. 4 Mar 1862
12
Wilder Holbrook
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.8.1.4]
b. 7 Apr 1795 d. 2 Jan 1855
12
Chloe Holbrook
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.8.1.5]
b. 13 Aug 1801 d. 11 Aug 1855
12
Henry Holbrook
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.8.1.6]
b. 19 Apr 1804 d. 10 Jul 1874
12
Ellery Holbrook
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.8.1.7]
b. 26 Jun 1810 d. 10 Jul 1847
11
Rachael Albee
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.8.2]
b. Abt 1748 d. 1832
11
Lois Albee
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.8.3]
b. 15 Feb 1759 d. 1841
11
Eunice Albee
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.8.4]
b. 20 Apr 1763 d. 1845
11
James Albee
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.8.5]
b. 11 Mar 1753 d. 18 Aug 1814
11
Abigail Albee
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.8.6]
b. 1747 d. 1844
11
Alpheus Albee
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.8.7]
b. 15 Feb 1761 d. 1847
11
Prudance Albe
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.8.8]
b. 18 Jan 1770 d. 1795
11
Abiel Albee
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.8.9]
b. 1756 d. 1827
10
Rachael White
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.9]
b. 14 Nov 1732 d. 19 Mar 1808
Thomas Darling
b. 7 May 1730 d. 22 Oct 1776
11
Seth Darling
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.9.1]
b. 21 Mar 1764 d. 27 Mar 1825
11
Nathan Darling
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.9.2]
b. 17 Dec 1770 d. 7 Sep 1855
11
Simeon Darling
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.9.3]
b. 21 Mar 1760 d. 4 Jun 1812
11
John Darling
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.9.4]
b. 9 Jun 1768
11
Alpheus Darling
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.9.5]
b. Abt 1770
11
Rhoda Darling
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.9.6]
b. 8 May 1750 d. 25 Jan 1842
11
Joanna Darling
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.9.7]
b. 1 Feb 1752
11
Rachel Darling
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.9.8]
b. 1 May 1755 d. Bef 1818
Reuben Holbrook
b. 18 Jul 1754 d. 1835
12
Abigail Holbrook
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.9.8.1]
b. 8 Jan 1778
12
Rachael Holbrook
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.9.8.2]
b. 8 Jan 1780 [
=>
]
12
Prudence Holbrook
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.9.8.3]
b. 25 Feb 1782
12
Anna Holbrook
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.9.8.4]
b. 30 Mar 1784 d. 16 Mar 1851 [
=>
]
12
Benjamin Holbrook
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.9.8.5]
b. 31 Jan 1786
11
Prudence Darling
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.9.9]
b. 28 Sep 1757 d. 1827
11
Benjamin Darling
[1.1.2.6.3.1.6.1.9.9.10]
b. 28 Feb 1766 d. Bef 14 Apr 1776
9
Lydia White
[1.1.2.6.3.1.6.1.10]
b. 10 May 1686
9
Thomas White
[1.1.2.6.3.1.6.1.11]
b. 26 Nov 1688 d. 10 Nov 1746
9
Hannah White
[1.1.2.6.3.1.6.1.12]
b. 9 Dec 1691 d. Abt 1761
9
Mary White
[1.1.2.6.3.1.6.1.13]
b. 1692 d. 1707
9
Abigail White
[1.1.2.6.3.1.6.1.14]
b. 10 Nov 1693 d. Bef 22 Mar 1720
9
Rachel White
[1.1.2.6.3.1.6.1.15]
b. 27 Dec 1694
8
Thomas White
[1.1.2.6.3.1.6.2]
b. 8 May 1680 d. 31 Mar 1762
8
Cornelius White
[1.1.2.6.3.1.6.3]
b. 28 Mar 1682 d. 21 Jan 1755
8
Benjamin White
[1.1.2.6.3.1.6.4]
b. 12 Oct 1684 d. 12 May 1724
8
Eleazar White
[1.1.2.6.3.1.6.5]
b. 8 Nov 1686 d. 14 Apr 1737
8
Ebenezer White
[1.1.2.6.3.1.6.6]
b. 3 Aug 1691 d. 18 May 1733
7
Isaac Hunt
[1.1.2.6.3.1.7]
b. Abt 1647 d. 12 Dec 1680
5
Mary Best
[1.1.2.6.4]
c. 14 Aug 1586 d. 1615
5
Elizabeth "Bridget" Best
[1.1.2.6.5]
b. 9 Apr 1592 d. Nov 1638
Abraham Shaw
b. 2 Jan 1590 d. 2 Nov 1638
6
Susanna Grace Shaw
[1.1.2.6.5.1]
b. 15 Aug 1621 d. 21 Aug 1698
Nicholas Byram
b. Abt 1610 d. 13 Apr 1688
7
Abagail Byram
[1.1.2.6.5.1.1]
b. 1632 d. 1712
7
Experience Byram
[1.1.2.6.5.1.2]
b. 1637 d. 1712
7
Deliverance Byram
[1.1.2.6.5.1.3]
b. 1638 d. 30 Sep 1720
John Porter
b. 1638 d. 7 Aug 1717
8
Thomas Porter
[1.1.2.6.5.1.3.1]
b. 1660 d. Abt 1754
8
Mary Porter
[1.1.2.6.5.1.3.2]
b. 22 Oct 1662 d. 24 Dec 1746
Wiliam Petty
b. 12 May 1661 d. 6 Jun 1728
9
Mary Petty
[1.1.2.6.5.1.3.2.1]
b. Abt 1690 d. 1756
9
Nathanial Petty
[1.1.2.6.5.1.3.2.2]
b. 14 Jun 1691 d. 17 Aug 1747
Mary Stowell
b. 17 Nov 1693 d. 20 Apr 1740
10
William Petty
[1.1.2.6.5.1.3.2.2.1]
b. 14 Sep 1715 d. 1753
Abigail Cox
b. 31 Jan 1722
11
William Petty
[1.1.2.6.5.1.3.2.2.1.1]
b. 23 Feb 1742
11
Joseph
[1.1.2.6.5.1.3.2.2.1.2]
b. Abt 1742
11
James Petty
[1.1.2.6.5.1.3.2.2.1.3]
b. 29 Aug 1745 d. 27 Jan 1764
11
Betty Petty
[1.1.2.6.5.1.3.2.2.1.4]
b. 31 Dec 1746 d. 1793
Jonathan Hadlock
b. 14 Jul 1742 d. 1801
12
Abigail Hadlock
[1.1.2.6.5.1.3.2.2.1.4.1]
b. 19 Mar 1769 d. 4 Apr 1769
12
Samuel Hadlock
[1.1.2.6.5.1.3.2.2.1.4.2]
b. 18 Jun 1770
12
Hezekiah Hadlock
[1.1.2.6.5.1.3.2.2.1.4.3]
b. 10 Aug 1772 d. 12 Dec 1855
12
Jonathan Hadlock
[1.1.2.6.5.1.3.2.2.1.4.4]
b. 28 Aug 1774
12
Joseph Hadlock
[1.1.2.6.5.1.3.2.2.1.4.5]
b. 4 Mar 1777 d. 4 Jun 1849
12
Elizabeth "Betsey" Hadlock
[1.1.2.6.5.1.3.2.2.1.4.6]
b. 24 Mar 1779 d. 1832
12
Peter Hadlock
[1.1.2.6.5.1.3.2.2.1.4.7]
b. 16 Sep 1781
12
Mariam Hadlock
[1.1.2.6.5.1.3.2.2.1.4.8]
b. 2 Mar 1784 d. 29 Jun 1851
12
Rhoda Hadlock
[1.1.2.6.5.1.3.2.2.1.4.9]
b. Feb 1786
12
Stephan A Hadlock
[1.1.2.6.5.1.3.2.2.1.4.10]
b. 12 Feb 1790 d. 9 Sep 1847 [
=>
]
12
Amos Ward Hadlock
[1.1.2.6.5.1.3.2.2.1.4.11]
b. 6 Apr 1793
10
Nathanial Petty
[1.1.2.6.5.1.3.2.2.2]
b. 6 Aug 1718 d. 20 Apr 1740
10
Thomas Petty
[1.1.2.6.5.1.3.2.2.3]
b. 5 Feb 1721 d. Aft 1751
10
John Petty
[1.1.2.6.5.1.3.2.2.4]
b. 23 Mar 1725 d. 17 Aug 1747
10
Mary Petty
[1.1.2.6.5.1.3.2.2.5]
b. 10 Mar 1729
10
Sarah Petty
[1.1.2.6.5.1.3.2.2.6]
b. 9 Sep 1732
10
Ruth Petty
[1.1.2.6.5.1.3.2.2.7]
b. 30 Jun 1742
9
Thomas Petty
[1.1.2.6.5.1.3.2.3]
b. 1692 d. 9 Nov 1716
9
Ruth Petty
[1.1.2.6.5.1.3.2.4]
b. Abt 1694 d. 15 Sep 1738
9
John Petty
[1.1.2.6.5.1.3.2.5]
b. 1696 d. 4 Sep 1716
9
Deliverance Petty
[1.1.2.6.5.1.3.2.6]
b. 1698 d. 21 Aug 1802
8
Susanna Porter
[1.1.2.6.5.1.3.3]
b. 2 Jun 1665 bur. 1761
8
Sergeant John Porter
[1.1.2.6.5.1.3.4]
b. 2 Jul 1667 d. 22 May 1723
8
Samuel Byram Porter
[1.1.2.6.5.1.3.5]
b. 20 Mar 1670 d. 31 Aug 1725
8
Nicholas Porter
[1.1.2.6.5.1.3.6]
b. 11 Apr 1672 d. 31 Dec 1773
8
Lieutenant Ebenezer Porter
[1.1.2.6.5.1.3.7]
b. Abt 1674 d. 1763
8
Ruth Porter
[1.1.2.6.5.1.3.8]
b. 18 Sep 1676 d. Aft 1739
8
Sarah Porter
[1.1.2.6.5.1.3.9]
b. 1680 d. 3 Mar 1741
7
Nicholas Byram
[1.1.2.6.5.1.4]
b. 1640 d. 20 Sep 1727
7
Mary Byram
[1.1.2.6.5.1.5]
b. 16 Sep 1646 d. Aft 1709
7
Susanna Byram
[1.1.2.6.5.1.6]
b. 1648 d. 12 Mar 1742
6
Joseph Shaw
[1.1.2.6.5.2]
b. 14 Mar 1618 d. 13 Dec 1653
6
Grace Shaw
[1.1.2.6.5.3]
b. 15 Aug 1621 d. 21 Aug 1698
6
Martha Shaw
[1.1.2.6.5.4]
b. 1 Dec 1623 d. 31 Mar 1625
6
Abigail Shaw
[1.1.2.6.5.5]
b. 1626
6
Maria "Mary" Shaw
[1.1.2.6.5.6]
b. 18 Jun 1626 d. 25 Mar 1658
6
John Shaw
[1.1.2.6.5.7]
b. 2 Mar 1629 d. 30 Jul 1701
3
Richard Swift
[1.1.3]
b. 1532 d. 1592
3
Hugh Swift
[1.1.4]
b. 1534 d. 1594
3
Ann Swift
[1.1.5]
b. 1535 d. 10 Mar 1576
Richard Jessup
b. 1530 d. 26 Nov 1580
4
William Jessup
[1.1.5.1]
b. 1562 d. 8 Sep 1630
4
Richard Jessup
[1.1.5.2]
b. 1563 d. 9 Jul 1594
4
Margaret Jessup
[1.1.5.3]
b. 1565 d. Abt 1616
4
Francis Jessup
[1.1.5.4]
b. 13 Nov 1569 d. Aft 1624
Frances White
b. 1585 d. Jul 1637
5
John Jessup
[1.1.5.4.1]
b. 1602 d. Feb 1638
5
Edward Jessup
[1.1.5.4.2]
b. 1607 d. 1666
5
Simon Jessup
[1.1.5.4.3]
b. 1610
4
Marie Jessup
[1.1.5.5]
b. 20 May 1571
4
Susan Jessup
[1.1.5.6]
b. 1575 d. 1675
3
John Swift
[1.1.6]
b. 1536 d. 1596
3
Henry Swift
[1.1.7]
b. 1538 d. 1598