Home Page
|
What's New
|
Photos
|
Histories
|
Headstones
|
Reports
|
Surnames
Search
First Name:
Last Name:
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Suomalainen
Svenska
Elizabeth Jennett Redmayne
1500 - 1586 (86 years)
Submit Photo / Document
Individual
Descendants
Relationship
Timeline
Submit Photo / Doc
Worksheet
Family
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Elizabeth Jennett Redmayne
[1]
b. 1500 d. 16 Jun 1586
Sir Edmund Parker
b. 1498 d. 1548
2
William Parker
[1.1]
b. 1519 d. 1527
2
John Parker
[1.2]
b. 1520 d. 25 Apr 1575
2
Giles Parker
[1.3]
b. 1524 d. 1533
2
Nicholas Parker
[1.4]
b. 1526 d. 28 Sep 1557
2
Robert Redmayne Parker
[1.5]
b. 1528 d. 28 Sep 1548
Elizabeth Chadderton
b. 1536 d. Bef 1646
3
Edmond Parker
[1.5.1]
b. 1555 d. Abt 1575
3
Robert Parker
[1.5.2]
b. 1556 d. 1614
Mary Eydith Burge
b. 1555 d. 10 Oct 1649
4
Robert Parker
[1.5.2.1]
b. 1569 d. 1614
Dorothy Stevens
b. Abt 1569 d. 11 Apr 1650
5
Sarah Parker
[1.5.2.1.1]
b. 15 Apr 1583 d. 9 Dec 1637
+
Thomas Bailey
b. 1578 d. Bef 1680
Reverend John Woodbridge
b. Abt 1582 d. 9 Dec 1637
6
Reverend John Woodbridge
[1.5.2.1.1.1]
b. 1613 d. 17 Mar 1696
6
Sarah Woodbridge
[1.5.2.1.1.2]
b. 1614
6
Tymothie Woodbridge
[1.5.2.1.1.3]
b. 1614 d. Bef 1649
6
Hester Woodbridge
[1.5.2.1.1.4]
b. Abt 1618 d. Bef 1649
6
Reverend Benjamin Woodbridge
[1.5.2.1.1.5]
b. 1622 d. 1 Nov 1684
6
Lucy Woodbridge
[1.5.2.1.1.6]
b. Apr 1623
5
Elizabeth Parker
[1.5.2.1.2]
b. 1590 d. 1653
5
Thomas Parker
[1.5.2.1.3]
d. 24 Apr 1677
4
Richard Parker
[1.5.2.2]
b. Abt 1572 d. 8 Jul 1636
+
Mary Baiford
b. Abt 1576
4
Anne Parker
[1.5.2.3]
b. Jun 1575 d. 7 Mar 1657
Richard Noyes
b. 1565 d. 25 Aug 1639
5
Peter Noyes
[1.5.2.3.1]
b. 1591 d. 23 Sep 1657
5
Elizabeth Noyes
[1.5.2.3.2]
b. 1610 d. Bef 1698
Thomas Hapgood
b. 1601 d. 1666
6
John Hapgood
[1.5.2.3.2.1]
b. 2 Apr 1632
Joan Blake
b. Abt 1636
7
John Hapgood
[1.5.2.3.2.1.1]
b. 2 Feb 1664
Elizabeth Dear
8
William Hopgood
[1.5.2.3.2.1.1.1]
b. 27 Jul 1702
8
Joan Hopgood
[1.5.2.3.2.1.1.2]
b. 14 May 1705
Robert White
b. 17 Jun 1700
9
William White
[1.5.2.3.2.1.1.2.1]
b. 1730
Elizabeth Futcher
b. 5 Mar 1741 d. 1775
10
William White
[1.5.2.3.2.1.1.2.1.1]
c. 9 Feb 1759 d. 1803
Elizabeth Greenwood
b. 1763 d. 26 Jul 1844
11
James White
[1.5.2.3.2.1.1.2.1.1.1]
b. 8 Aug 1787 d. 2 Oct 1867
Charlotte Newington
b. 22 Nov 1789 d. 14 Aug 1820
12
Mary Ann White
[1.5.2.3.2.1.1.2.1.1.1.1]
b. 9 May 1815 d. Abt 1845 [
=>
]
12
George White
[1.5.2.3.2.1.1.2.1.1.1.2]
b. 20 Jul 1817 d. 26 Jan 1861
12
James White
[1.5.2.3.2.1.1.2.1.1.1.3]
b. 3 Apr 1818 d. 12 Feb 1869 [
=>
]
Mary Newington
b. Jul 1800 bur. 16 Jan 1871
12
Henry White
[1.5.2.3.2.1.1.2.1.1.1.4]
b. 18 Jan 1823
12
William White
[1.5.2.3.2.1.1.2.1.1.1.5]
b. 1826 d. Jul 1871
12
Harriet White
[1.5.2.3.2.1.1.2.1.1.1.6]
b. 2 Jul 1828
12
Charles White
[1.5.2.3.2.1.1.2.1.1.1.7]
b. 1831
12
Thomas Richard White
[1.5.2.3.2.1.1.2.1.1.1.8]
b. 17 Feb 1833 bur. 4 Apr 1869
8
Ann Hopgood
[1.5.2.3.2.1.1.3]
c. 5 May 1697
7
Elizabeth Hapgood
[1.5.2.3.2.1.2]
b. Abt 1659
7
Mary Hapgood
[1.5.2.3.2.1.3]
b. Abt 1661
7
Elinor Hapgood
[1.5.2.3.2.1.4]
b. Abt 1663
6
Nathaniel Hapgood
[1.5.2.3.2.2]
b. Bef 1638
6
Thomas Hapgood
[1.5.2.3.2.3]
b. Bef 1640
6
Shadrack Hapgood
[1.5.2.3.2.4]
b. Abt 1642 d. 2 Aug 1675
Elizabeth Treadway
b. 3 Aug 1646 d. 18 Sep 1714
7
Nathaniel Hapgood
[1.5.2.3.2.4.1]
b. 21 Oct 1665 d. 3 Dec 1727
Elizabeth Ward
b. 21 Mar 1672 d. 5 Nov 1748
8
Nathaniel Hapgood
[1.5.2.3.2.4.1.1]
b. Abt 1696 d. Abt 1746
8
Shadrach Hapgood
[1.5.2.3.2.4.1.2]
b. Abt 1702 d. 13 May 1768
Elizabeth Wetherbee
b. 21 Apr 1715 d. 30 Nov 1808
9
Mary Mercy Hapgood
[1.5.2.3.2.4.1.2.1]
b. 26 Jan 1732 d. 23 Oct 1815
9
Elizabeth Hapgood
[1.5.2.3.2.4.1.2.2]
b. 26 Sep 1734 d. 13 Nov 1803
9
Phineas Hapgood
[1.5.2.3.2.4.1.2.3]
b. 1737 d. Aug 1737
9
Asa Hapgood
[1.5.2.3.2.4.1.2.4]
b. 1739 d. 16 Aug 1743
9
Israel Hapgood
[1.5.2.3.2.4.1.2.5]
b. 1741 d. 2 Mar 1743
9
Sarah Hopgood
[1.5.2.3.2.4.1.2.6]
b. 16 Jun 1744
John Daby
b. Abt 1724
10
Simon Daby
[1.5.2.3.2.4.1.2.6.1]
b. 20 Mar 1765 d. 18 Dec 1802
10
Asa Daby
[1.5.2.3.2.4.1.2.6.2]
b. 3 Feb 1767 d. 10 Aug 1813
10
Mercy Daby
[1.5.2.3.2.4.1.2.6.3]
b. 11 May 1769
10
Sarah Daby
[1.5.2.3.2.4.1.2.6.4]
b. 7 Feb 1772
Josiah Stone
b. 1 Apr 1771
11
Josiah Stone
[1.5.2.3.2.4.1.2.6.4.1]
b. 29 Dec 1797
11
Levi Stone
[1.5.2.3.2.4.1.2.6.4.2]
b. 5 Sep 1799
11
Ezra Stone
[1.5.2.3.2.4.1.2.6.4.3]
b. 8 Dec 1801
11
Sarah Stone
[1.5.2.3.2.4.1.2.6.4.4]
b. 21 Apr 1805 d. 1849
Lucius Augustus Bingham
b. 1 Sep 1804
12
Calvin Bingham
[1.5.2.3.2.4.1.2.6.4.4.1]
b. 7 Sep 1827 d. 27 May 1883
12
Benjamin Bingham
[1.5.2.3.2.4.1.2.6.4.4.2]
b. 1829 d. 27 May 1883
12
Augustus Bingham
[1.5.2.3.2.4.1.2.6.4.4.3]
b. 27 Oct 1831 d. 20 May 1908
12
Levi Perry Bingham
[1.5.2.3.2.4.1.2.6.4.4.4]
b. 5 Nov 1832 d. 9 Oct 1903 [
=>
]
12
Son Bingham
[1.5.2.3.2.4.1.2.6.4.4.5]
b. 10 May 1834 d. Abt 1835
12
Mary Emiline Bingham
[1.5.2.3.2.4.1.2.6.4.4.6]
b. 10 May 1834 d. 1874
12
Prosper Bingham
[1.5.2.3.2.4.1.2.6.4.4.7]
b. 1840 d. Abt 1845
12
Lucy Bingham
[1.5.2.3.2.4.1.2.6.4.4.8]
b. 1843
10
Betsey Daby
[1.5.2.3.2.4.1.2.6.5]
b. 7 Mar 1774
10
John Daby
[1.5.2.3.2.4.1.2.6.6]
b. 9 Jan 1779 d. 16 May 1789
9
Shadrach Hapgood
[1.5.2.3.2.4.1.2.7]
b. 1745 d. 20 Jan 1818
9
Oliver Hapgood
[1.5.2.3.2.4.1.2.8]
b. 1747 d. 7 Oct 1751
9
Lydia Hapgood
[1.5.2.3.2.4.1.2.9]
b. Abt 1751 d. 16 Dec 1834
8
Deacon Daniel Hapgood
[1.5.2.3.2.4.1.3]
b. 1706 d. 30 Apr 1791
8
Sarah Hapgood
[1.5.2.3.2.4.1.4]
b. Abt 1708
7
Mary Habgood
[1.5.2.3.2.4.2]
b. 2 Nov 1667 d. 13 Jan 1692
7
Thomas Hapgood
[1.5.2.3.2.4.3]
b. 1 Feb 1669 d. 4 Oct 1764
7
Sarah Hapgood
[1.5.2.3.2.4.4]
b. 1672 d. Aft 1730
7
Elizabeth Hapgood
[1.5.2.3.2.4.5]
b. 1674 d. 20 Jul 1689
Reverend William Noyes
b. 1568 d. 30 Apr 1622
5
Ephraim Noyes
[1.5.2.3.3]
b. 1596 d. 28 Oct 1659
+
Parnell Brewer
b. 1597 d. Abt 1659
5
Reverend Nathan Noyes
[1.5.2.3.4]
b. 15 May 1597 d. 6 Sep 1651
Mary Parker
b. Abt 1602 d. 1657
6
Abigail Noyes
[1.5.2.3.4.1]
b. Abt 1630
6
Elizabeth Noyes
[1.5.2.3.4.2]
b. Abt 1628
6
Nathan Noyes
[1.5.2.3.4.3]
b. Abt 1622
6
Marie Noyes
[1.5.2.3.4.4]
b. Abt 1626
6
Rachel Noyes
[1.5.2.3.4.5]
b. Aft 1630 d. 1651
5
Sarah Noyes
[1.5.2.3.5]
b. Abt 1602 d. 16 Oct 1671
5
Reverend James Noyes
[1.5.2.3.6]
b. 22 Oct 1608 d. 22 Oct 1656
Sarah Browne
b. 1610 d. 13 Sep 1691
6
Joseph Noyes
[1.5.2.3.6.1]
b. 15 Oct 1637 d. 16 Nov 1717
Mary Darvell
b. 10 May 1642 d. 24 Sep 1677
7
Joseph Noyes
[1.5.2.3.6.1.1]
b. 16 Aug 1663
7
Sarah Noyes
[1.5.2.3.6.1.2]
b. 28 Sep 1669 d. Sep 1756
7
Rebecca Noyes
[1.5.2.3.6.1.3]
b. 22 Sep 1671 d. 17 Nov 1734
7
Moses Noyes
[1.5.2.3.6.1.4]
b. 9 Sep 1667 d. 19 May 1689
7
Thomas Noyes
[1.5.2.3.6.1.5]
b. 13 Sep 1667 d. 13 Sep 1667
7
Mary Noyes
[1.5.2.3.6.1.6]
b. 22 Jun 1666 d. 11 Jan 1743
7
Lieutenant John Noyes
[1.5.2.3.6.1.7]
b. 9 Mar 1674 d. 15 Apr 1765
6
Reverend James Noyes
[1.5.2.3.6.2]
b. 11 Mar 1640 d. 30 Dec 1719
Dorothy Stanton
b. Abt 1650 d. 19 Jan 1742
7
John Noyes
[1.5.2.3.6.2.1]
b. 13 Jan 1685 d. 17 Sep 1751
7
Joseph Noyes
[1.5.2.3.6.2.2]
b. 16 Oct 1688 d. 14 Jun 1761
7
Moses Noyes
[1.5.2.3.6.2.3]
b. 19 Mar 1692 d. 30 Apr 1692
7
Dorothy Noyes
[1.5.2.3.6.2.4]
b. 20 Jan 1676 d. 6 Dec 1714
7
Anna Noyes
[1.5.2.3.6.2.5]
b. 16 Apr 1682 d. 28 Jun 1694
7
James Noyes
[1.5.2.3.6.2.6]
c. 21 Oct 1677 bur. 1718
7
Thomas Noyes
[1.5.2.3.6.2.7]
b. 15 Aug 1679 d. 26 Jun 1755
6
Reverend Moses Noyes
[1.5.2.3.6.3]
b. 23 Sep 1648 d. 25 Oct 1734
Ruth Pickett
b. 16 Dec 1653 d. 14 Sep 1690
7
Naomi Noyes
[1.5.2.3.6.3.1]
b. Abt 1676 d. 15 Mar 1728
William Comstock
b. 8 Jan 1669 d. 15 Mar 1728
8
John Comstock
[1.5.2.3.6.3.1.1]
b. 9 Aug 1696 d. 28 Mar 1767
Rebecca Bates
b. Abt 1704
9
Phebe Comstock
[1.5.2.3.6.3.1.1.1]
b. 16 Nov 1727
9
Curtis Comstock
[1.5.2.3.6.3.1.1.2]
b. 8 Oct 1729 d. 1772
9
Rebecca Comstock
[1.5.2.3.6.3.1.1.3]
b. 11 Feb 1732
9
Gideon Comstock
[1.5.2.3.6.3.1.1.4]
b. Abt 1736 d. 1746
8
William Comstock
[1.5.2.3.6.3.1.2]
b. 15 Jun 1698 d. 19 Jun 1765
Mary Bates
b. 1 Jul 1711 d. 29 Mar 1743
9
Abigail Comstock
[1.5.2.3.6.3.1.2.1]
c. 27 Apr 1726 d. 1776
9
William Comstock
[1.5.2.3.6.3.1.2.2]
b. 1733 d. 1773
9
Anne Comstock
[1.5.2.3.6.3.1.2.3]
b. Abt 1737
9
Naomi Comstock
[1.5.2.3.6.3.1.2.4]
b. 1739 d. 21 Dec 1831
9
Ruth Comstock
[1.5.2.3.6.3.1.2.5]
b. 18 Apr 1741 d. 18 Apr 1804
8
Abigail Comstock
[1.5.2.3.6.3.1.3]
b. 1700 d. 16 Oct 1773
Joseph Lord
b. 17 Oct 1697 d. 25 Jul 1736
9
Abigail Lord
[1.5.2.3.6.3.1.3.1]
b. 3 Feb 1726 d. 1771
9
Joseph Lord
[1.5.2.3.6.3.1.3.2]
b. 3 Feb 1726 d. 13 Mar 1788
9
Benjamin Lord
[1.5.2.3.6.3.1.3.3]
b. 3 Jan 1728 d. 6 Feb 1805
9
Elijah Lord
[1.5.2.3.6.3.1.3.4]
b. 1 Jan 1730
9
Elizabeth Lord
[1.5.2.3.6.3.1.3.5]
b. 19 Aug 1732 d. 20 Dec 1753
9
Sylvanus Lord
[1.5.2.3.6.3.1.3.6]
b. 21 Aug 1734 d. 29 Nov 1762
9
Captain Daniel Lord
[1.5.2.3.6.3.1.3.7]
b. 1736 d. 21 Sep 1796
8
Ruth Comstock
[1.5.2.3.6.3.1.4]
b. Abt 1702
+
Jonathan Reed
b. 15 Apr 1686
8
Elizabeth Comstock
[1.5.2.3.6.3.1.5]
b. Abt 1704
+
McCrary
b. 1702
8
Phoebe Comstock
[1.5.2.3.6.3.1.6]
b. 1706 d. 1 Dec 1790
Lemuel Griffin
b. 23 Mar 1706 d. 15 Aug 1788
9
George Griffin
[1.5.2.3.6.3.1.6.1]
b. 10 Jul 1734 d. 6 Aug 1814
9
Lemuel Griffin
[1.5.2.3.6.3.1.6.2]
b. Abt 1736 d. 9 Jul 1810
9
Josiah Griffen
[1.5.2.3.6.3.1.6.3]
b. 21 Jul 1743
8
Naomi Comstock
[1.5.2.3.6.3.1.7]
b. 1708 d. 29 May 1743
Consider Tiffany
b. 28 Apr 1703 d. 29 May 1763
9
Consider Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.1]
b. 15 Mar 1732 d. 19 Jun 1796
Sarah Wilder
b. 13 Aug 1738 d. 7 Nov 1818
10
Jemima Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.1.1]
b. 12 Oct 1756 d. 24 Jul 1784
10
Ephriam Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.1.2]
b. 8 Nov 1758 d. 7 Apr 1818
10
Dorothy Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.1.3]
b. 19 Jun 1762 d. 7 Nov 1818
10
Levi Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.1.4]
b. 23 Apr 1766 d. 20 Nov 1851
10
Consider Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.1.5]
b. 12 Mar 1769 d. 4 Sep 1859
10
Betty Wilder Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.1.6]
b. 25 Feb 1772 d. 16 Feb 1837
10
Mary Willey Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.1.7]
b. 1 Apr 1775
10
Lewis Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.1.8]
b. Abt 1777 d. 13 Nov 1777
10
Dolly Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.1.9]
b. Abt 1779
9
Luther Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.2]
b. 15 Apr 1734
9
Naomi Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.3]
b. 28 Dec 1737 d. 25 Jul 1821
Ezekial Huntley
b. 9 Mar 1728 d. 25 Jul 1783
10
Rufus Huntley
[1.5.2.3.6.3.1.7.3.1]
b. 18 Sep 1764 d. 4 Apr 1860
10
Lois Huntley
[1.5.2.3.6.3.1.7.3.2]
b. 18 Sep 1764 d. 2 Feb 1848
10
Elias Huntley
[1.5.2.3.6.3.1.7.3.3]
b. 28 Jul 1765 d. 10 Jan 1783
10
Asher Hulbert
[1.5.2.3.6.3.1.7.3.4]
b. 1 Mar 1767 d. 1 Mar 1849
10
Naomi Huntley
[1.5.2.3.6.3.1.7.3.5]
b. Abt 1768 d. 2 Dec 1840
10
Ezra Huntley
[1.5.2.3.6.3.1.7.3.6]
b. 2 Jun 1771 d. 13 Apr 1817
10
Ezekiel Huntley, Jr
[1.5.2.3.6.3.1.7.3.7]
b. 21 May 1780 d. 5 Mar 1853
9
Samuel Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4]
b. 13 Jul 1740 d. Mar 1822
Abigail Curtis
b. 17 Mar 1742 d. May 1820
10
Samuel Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.1]
b. 21 Oct 1761 d. 21 Apr 1851
Mary Sackett
b. Abt 1761 d. 1862
11
Samuel Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.1.1]
b. 1788 d. Abt 1845
11
Mary Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.1.2]
b. 1797
11
Julia Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.1.3]
b. 1799 d. 13 Jan 1891
11
Thomas Jefferson Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.1.4]
b. 1801
11
Hannah Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.1.5]
b. 5 Apr 1804 d. 10 Sep 1860
11
Calinda Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.1.6]
b. 2 Dec 1807 d. 5 Mar 1866
11
Ezekiel Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.1.7]
b. 1810
11
Jefferson Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.1.8]
b. Abt 1810
11
Harry Edward Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.1.9]
b. 25 Jun 1813 d. 14 Dec 1871
11
Harriet Emeline Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.1.10]
b. Abt 1815
11
Lorenzo Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.1.11]
b. Abt 1818
10
Nathanial Curtis Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.2]
b. 18 Feb 1762 d. 13 Feb 1857
Dency Crane
b. Abt 1765
11
Nathaniel Curtis Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.2.1]
b. Mar 1790
11
Harriet Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.2.2]
b. Mar 1792 d. 1858
11
Dancy Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.2.3]
b. 25 Sep 1795 d. 24 Mar 1846
11
Anron Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.2.4]
b. 2 Jun 1797 d. 27 Feb 1847
11
Betsey Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.2.5]
b. Abt 1799
11
David Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.2.6]
b. 1800
11
Mary Polly Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.2.7]
b. 17 Dec 1801 d. 20 May 1835
11
Elizabeth Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.2.8]
b. 1805
11
Caroline Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.2.9]
b. Abt 1807 d. 1843
10
Jemima Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.3]
b. 1763 d. 6 Mar 1848
Reuben Ward
b. 13 Nov 1748 d. 5 Jul 1825
11
Affa Ward
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.3.1]
b. 27 May 1783 d. 28 Feb 1877
William Stilson
b. 23 Sep 1783 d. 4 May 1862
12
Caroline Stilson
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.3.1.1]
b. 20 Jan 1808 d. 12 Jan 1883
12
Albert Stilson
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.3.1.2]
b. 16 Jan 1810 d. 30 Sep 1895
12
Celinda Stilson
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.3.1.3]
b. 4 Feb 1811 d. 26 Jun 1845
12
Emeline Stilson
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.3.1.4]
b. 27 Sep 1813 d. 6 Jan 1887
12
William M Stilson
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.3.1.5]
b. 2 Apr 1816
12
Saphronia Stilson
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.3.1.6]
b. 3 Nov 1817 d. 6 Jan 1887
12
Minor Stilson
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.3.1.7]
b. 9 Jan 1821
12
Affa C Stilson
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.3.1.8]
b. 31 Mar 1823 d. Abt 1879
12
Rueben R Stilson
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.3.1.9]
b. 29 Dec 1824
12
Allen Stilson
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.3.1.10]
b. 12 Apr 1827 d. 25 Jan 1878
11
Reuben Ward
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.3.2]
b. Abt 1784 d. 5 Mar 1876
11
Jemima Ward
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.3.3]
b. Abt 1786
11
Laura Ward
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.3.4]
b. Abt 1790
11
Eda Ward
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.3.5]
b. Abt 1788
11
Samuel Ward
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.3.6]
b. Abt 1792 d. 23 Feb 1873
11
Dorcas Ward
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.3.7]
b. Abt 1794
11
Cynthia Ward
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.3.8]
b. Abt 1796
+
Henry Rolluff
b. Abt 1782
11
William B Ward
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.3.9]
b. 1801
11
Daniel Ward
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.3.10]
b. 1807
10
William Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.4]
b. Abt 1765
10
Emellason Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.5]
b. Abt 1765 d. 18 Mar 1847
Sarah Aldrich
b. 4 Apr 1773
11
Rhoda Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.5.1]
b. 1 Nov 1793
11
George Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.5.2]
b. 5 May 1794
11
Lemuel Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.5.3]
b. 30 Jun 1796
11
David Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.5.4]
b. 18 Aug 1798
11
Sarah Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.5.5]
b. 27 Mar 1803 d. 14 Nov 1838
11
Silas Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.5.6]
b. 13 Apr 1809
10
Daniel Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.6]
b. 18 Sep 1768 d. 25 Sep 1793
+
Phebe Rand
b. Abt 1770
10
Abigail Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.7]
b. Abt 1770
+
Zenos Aldrich
b. 1766 d. 8 Nov 1856
10
George Obediah Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.8]
b. 7 May 1772 d. 13 Feb 1857
Mary Mason
b. Abt 1766 d. 16 Mar 1840
11
Abigail Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.8.1]
b. Abt 1797 d. Dec 1859
11
Zilpha Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.8.2]
b. Abt 1799 d. 1830
11
Zenas Schovil Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.8.3]
b. 25 Jun 1801 d. 1822
11
Luther Little Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.8.4]
b. 28 Mar 1803 d. 17 Feb 1881
11
Frederick Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.8.5]
b. 1804 d. 1804
11
Lorenzo Mason Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.8.6]
b. Abt 1804 d. Abt 1809
11
Jane Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.8.7]
b. 14 Apr 1805 d. 26 Nov 1867
11
George Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.8.8]
b. 4 May 1808 d. 21 Jun 1885
Almira Whipple
b. 13 Jun 1810 d. 4 Feb 1889
12
Cynthia Jane Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.8.8.1]
b. 2 Feb 1830 d. 6 Oct 1845
12
Zenos Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.8.8.2]
b. 21 Jul 1831 d. Dec 1843
12
Ira Patchen Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.8.8.3]
b. 14 Feb 1835 d. 21 Mar 1905 [
=>
]
12
Loyal Peck Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.8.8.4]
b. 27 Jul 1837 d. 15 Feb 1903
12
Mary Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.8.8.5]
b. 18 Dec 1844 d. 14 Dec 1845
12
Almira Rebecca Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.8.8.6]
b. 18 Aug 1847 d. 23 Nov 1914 [
=>
]
12
George Mason Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.8.8.7]
b. 31 Jan 1850 d. 14 Mar 1909 [
=>
]
12
Nelson Whipple Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.8.8.8]
b. 6 Aug 1852 d. 20 Jan 1927 [
=>
]
11
Lorenzo Roderick Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.8.9]
b. 4 Jul 1810 d. Abt 1810
11
Richard Mason Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.8.10]
b. 4 Jul 1810 d. 1897
11
Daniel Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.8.11]
b. 12 Sep 1812 d. 25 Jan 1894
11
Mary Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.8.12]
b. 28 Mar 1814 d. 1899
11
Phebe Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.8.13]
b. 24 Oct 1817 d. 20 Feb 1850
11
Larena Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.8.14]
b. 1818 d. 1844
11
Ann Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.8.15]
b. 4 Jun 1822 d. 12 Sep 1893
10
Mary Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9]
b. 17 Jun 1777 d. 12 Sep 1845
Daniel Whipple
b. 27 Aug 1779 d. 27 Sep 1839
11
Cynthia Whipple
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.1]
b. 15 Jan 1805 d. 1889
Ezra Gray
b. 1793 d. 1870
12
Hiram T Gray
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.1.1]
b. 25 Aug 1832 d. 30 Jun 1875
12
Daniel William Gray
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.1.2]
b. 19 May 1834 d. 9 Dec 1890 [
=>
]
12
Daughter Gray
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.1.3]
b. 1834
12
Emily Jane Gray
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.1.4]
b. 14 Nov 1837 d. 13 Feb 1908
12
Betsey T Gray
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.1.5]
b. 1840
12
Mary M Gray
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.1.6]
b. 1844
12
George W Gray
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.1.7]
b. 1846 d. 4 Aug 1918 [
=>
]
11
Samuel Whipple
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.2]
b. 21 Dec 1808 d. 9 Jan 1887
Phoebe Kingsbury
b. 14 Dec 1812 d. 24 Apr 1851
12
Sabrina Whipple
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.2.1]
b. 30 Mar 1832 d. 1920
12
George T Whipple
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.2.2]
b. 4 Dec 1833 d. 28 Aug 1868
12
Polly Whipple
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.2.3]
b. 4 Jun 1835 d. 24 Mar 1855
12
Daniel Whipple
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.2.4]
b. 21 Jun 1837
12
Margaret Whipple
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.2.5]
b. 18 Jun 1839 d. 8 Oct 1840
12
Mason Kingsbury Whipple
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.2.6]
b. 17 Feb 1842 d. 27 Mar 1919 [
=>
]
12
Samuel Whipple
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.2.7]
b. 4 Mar 1844 d. May 1924
12
Hassett Whipple
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.2.8]
b. 20 Feb 1846 d. 3 Jan 1852
12
Almira Whipple
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.2.9]
b. 21 Apr 1848 d. 22 Sep 1911
12
Cynthia Whipple
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.2.10]
b. 10 Nov 1850 d. 17 Apr 1851
11
Almira Whipple
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.3]
b. 13 Jun 1810 d. 4 Feb 1889
George Tiffany
b. 4 May 1808 d. 21 Jun 1885
12
Cynthia Jane Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.3.1]
b. 2 Feb 1830 d. 6 Oct 1845
12
Zenos Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.3.2]
b. 21 Jul 1831 d. Dec 1843
12
Ira Patchen Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.3.3]
b. 14 Feb 1835 d. 21 Mar 1905 [
=>
]
12
Loyal Peck Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.3.4]
b. 27 Jul 1837 d. 15 Feb 1903
12
Mary Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.3.5]
b. 18 Dec 1844 d. 14 Dec 1845
12
Almira Rebecca Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.3.6]
b. 18 Aug 1847 d. 23 Nov 1914 [
=>
]
12
George Mason Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.3.7]
b. 31 Jan 1850 d. 14 Mar 1909 [
=>
]
12
Nelson Whipple Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.3.8]
b. 6 Aug 1852 d. 20 Jan 1927 [
=>
]
11
Phoebe Whipple
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.4]
b. 13 Aug 1813 d. 18 Nov 1846
Benjamin Bengraw Shaw
b. 1808
12
Clymenia Azuba Shaw
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.4.1]
b. 2 Feb 1834 d. 10 Aug 1920 [
=>
]
Benjamin Gibson
b. 9 May 1805 d. 26 Nov 1897
12
Hannah Gibson
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.4.2]
b. 24 Apr 1836 d. 31 Oct 1846
12
Isabella Amy Gibson
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.4.3]
b. 20 Mar 1838 d. 11 Feb 1898 [
=>
]
12
Mary Jane Gibson
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.4.4]
b. 5 Feb 1840 d. 12 Jun 1912 [
=>
]
12
Susan Jane Gibson
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.4.5]
b. 11 Oct 1842 d. 25 May 1929 [
=>
]
12
Jemima Gibson
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.4.6]
b. 1847
11
Carum Whipple
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.5]
b. 12 Aug 1815 d. 1843
11
Gerua Whipple
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.6]
b. 12 Aug 1815 d. 18 Sep 1848
11
Nelson Wheeler Whipple
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.7]
b. 11 Jul 1818 d. 5 Jul 1887
Susan Jane Bailey
b. 9 Mar 1828 d. 5 Jun 1856
12
Son Whipple
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.7.1]
b. 15 Oct 1844 d. 15 Oct 1844
12
Miranda Jane Whipple
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.7.2]
b. 14 Mar 1847 d. 29 Dec 1907 [
=>
]
12
Mary Janet Whipple
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.7.3]
b. 14 Feb 1849 d. Nov 1922 [
=>
]
12
George Nelson Whipple
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.7.4]
b. 20 Mar 1851 d. 8 Jun 1912 [
=>
]
12
Edson Whipple
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.7.5]
b. 10 Oct 1853 d. 26 Feb 1909 [
=>
]
12
Harriet Emily Whipple
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.7.6]
b. 21 Nov 1855 d. 4 Oct 1856
12
Annie Bard Whipple
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.7.7]
b. 5 Jun 1856
Susan Ann Gay
b. 13 Jun 1841 d. 29 Sep 1911
12
Martha Ellen Whipple
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.7.8]
b. 19 Jan 1858 d. 20 Oct 1937 [
=>
]
12
Nelson Gay Whipple
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.7.9]
b. 21 Sep 1859 d. 2 Apr 1944 [
=>
]
12
Sylvia Gay Whipple
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.7.10]
b. 18 May 1862 d. 20 Jan 1940 [
=>
]
12
Susan Ann Whipple
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.7.11]
b. 3 Nov 1864 d. 19 Dec 1935 [
=>
]
12
Alexander Samuel Whipple
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.7.12]
b. 2 Mar 1867 d. 8 Jan 1899 [
=>
]
12
Robert John Whipple
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.7.13]
b. 13 Nov 1869 d. 6 Nov 1954 [
=>
]
12
Amey Jane Whipple
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.7.14]
b. 15 Dec 1871 d. 6 Sep 1962 [
=>
]
12
Ida Whipple
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.7.15]
b. 15 Dec 1873 d. 21 May 1956 [
=>
]
12
Anor Whipple
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.7.16]
b. 25 Mar 1879 d. 23 Oct 1967 [
=>
]
Rachel Keeling
b. 10 Mar 1818 d. 16 Jun 1910
12
Daniel Whipple
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.7.17]
b. 12 Apr 1854 d. 12 Feb 1926 [
=>
]
12
Cynthia Delight Whipple
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.7.18]
b. 7 Jun 1857 d. 4 Sep 1858
12
Nelson Wheeler Whipple, Jr
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.7.19]
b. 15 Apr 1859 d. 30 Jun 1938 [
=>
]
Zenos Aldrich
b. Abt 1773 d. 8 Nov 1856
11
Sylvanus Aldrich
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.8]
b. 1799 d. 8 Nov 1856
11
Azuba Aldrich
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.9]
b. Abt 1801
Armstrong Baskins
b. 3 Apr 1786 d. 27 May 1842
12
Sarah Ann Baskins
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.9.1]
b. Abt 1824
12
Harriet N Baskins
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.9.2]
b. Abt 1830
12
Mary Jane Baskins
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.9.3]
b. 1832 d. 22 Dec 1850
12
Erastus Baskins
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.9.9.4]
b. 1834 d. 3 Nov 1862
10
Azuba Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.10]
b. 22 Aug 1779 d. 13 Nov 1865
Jared Patchen
b. 5 Sep 1773 d. 1 May 1857
11
Martin Ray Patchen
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.10.1]
b. 10 Feb 1799 d. 7 Feb 1842
11
Abigail Patchen
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.10.2]
b. 23 Jan 1801 d. 7 Sep 1823
11
Emily Patchen
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.10.3]
b. 1802 d. 16 Jul 1826
11
John Patchen
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.10.4]
b. 14 Jan 1803 d. 23 Oct 1874
11
Ira Patchen
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.10.5]
b. 10 Jun 1805
11
Polly Patchen
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.10.6]
b. 20 Jan 1808 d. 21 Aug 1891
11
Mary Patchen
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.10.7]
b. 20 Jan 1808 d. 23 Feb 1888
11
Jared Patchen
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.10.8]
b. 6 Sep 1812
11
Sylvanus Aldridge Patchen
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.10.9]
b. 27 Nov 1814 d. 10 Feb 1892
11
Azuba Ann Patchen
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.10.10]
b. 4 Jun 1817 d. 29 Sep 1886
11
Hannah Lavinia Patchen
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.10.11]
b. 24 Apr 1820
11
Samuel Lorenzo Patchen
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.10.12]
b. 1 Aug 1823 d. 14 Jun 1867
11
Amy Patchen
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.10.13]
b. Abt 5 Jul 1825
10
Phoebe Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.11]
b. 22 Aug 1781 d. 31 Dec 1855
Nathan S Stewart
b. 7 Mar 1771 d. 7 Aug 1866
11
Horace S Stewart
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.11.1]
b. 15 Jun 1804 d. 7 Aug 1866
11
Erastus A Stewart
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.11.2]
b. 10 Mar 1805 d. 10 Nov 1851
11
Elijah Burr Stewart
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.11.3]
b. Abt 1809 d. 9 Nov 1880
11
Azuba Ann Stewart
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.11.4]
b. 1810
11
Samuel Curtis Stewart
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.11.5]
b. 1811 d. 25 Nov 1870
11
William Stewart
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.11.6]
b. 1812
11
Azubam Stewart
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.11.7]
b. 1812
11
Thomas Ryler Stewart
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.11.8]
b. 1815
10
Amy Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.12]
b. 8 Dec 1783 d. 17 Dec 1857
Isaac Darrow
b. Abt 1779
11
John Tiffany Darrow
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.12.1]
b. 17 Nov 1800 d. 13 Nov 1897
11
Affa Ward Darrow
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.12.2]
b. 26 Dec 1803 d. 15 Apr 1875
11
Hannah Mead Darrow
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.12.3]
b. 24 Apr 1806
11
Mary Cromwell Darrow
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.12.4]
b. 9 May 1808 d. 18 Nov 1877
11
Ann Hubbard Darrow
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.12.5]
b. 27 Mar 1811 d. 24 Jul 1890
11
Susan Pardee Darrow
[1.5.2.3.6.3.1.7.4.12.6]
b. 1813 d. 24 Jun 1890
9
Humphery Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.5]
b. 2 Mar 1742 d. 1831
Phebe Brown
b. Abt 1751 d. 1831
10
Lydia "Lidda" Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.5.1]
b. 13 May 1772 d. 1 Jul 1856
10
Susanna Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.5.2]
b. 28 Feb 1774
10
John C Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.5.3]
b. 17 Dec 1776 d. 9 Jul 1855
10
William Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.5.4]
b. Abt 1781 d. 12 Oct 1866
10
Phebe Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.5.5]
b. 1783
10
Humphrey Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.5.6]
b. 13 Sep 1788 d. 24 Jun 1870
10
Nelson Tiffany
[1.5.2.3.6.3.1.7.5.7]
b. 13 Sep 1808 d. 7 Sep 1869
8
Mary Comstock
[1.5.2.3.6.3.1.8]
b. Abt 1710
Nathan Beckwith
b. 22 Feb 1717 d. 24 Dec 1747
9
Mary Beckwith
[1.5.2.3.6.3.1.8.1]
b. Abt 1740 d. 10 Sep 1834
9
Ransom Beckwith
[1.5.2.3.6.3.1.8.2]
b. 12 Aug 1747
8
Samuel Comstock
[1.5.2.3.6.3.1.9]
b. Abt 1712 d. 1787
7
Moses Noyes
[1.5.2.3.6.3.2]
b. 1 Aug 1678 d. 10 Oct 1743
Mary Ely
b. 29 Nov 1689 d. 3 Feb 1764
8
Ruth Noyes
[1.5.2.3.6.3.2.1]
b. 1722 d. 14 May 1725
8
Moses Noyes
[1.5.2.3.6.3.2.2]
b. 1 Sep 1714 d. 23 Jul 1753
8
Ruth Noyes
[1.5.2.3.6.3.2.3]
b. 6 Jan 1716 d. 5 Feb 1719
8
Elizabeth Noyes
[1.5.2.3.6.3.2.4]
b. 1730 d. 8 May 1819
Jabez Sill
b. 4 Aug 1722 d. 14 Mar 1795
9
Elizabeth Noyes Sill
[1.5.2.3.6.3.2.4.1]
b. 22 Oct 1750 d. 27 Apr 1812
9
Mary Sill
[1.5.2.3.6.3.2.4.2]
b. 11 Jul 1752 d. 22 Apr 1842
9
Naomi Sill
[1.5.2.3.6.3.2.4.3]
b. 28 Nov 1754 d. 1838
9
Esther Sill
[1.5.2.3.6.3.2.4.4]
b. 1755 d. 7 Aug 1817
9
Shadrach Sill
[1.5.2.3.6.3.2.4.5]
b. 12 Aug 1758 d. 3 Nov 1813
9
Moses Sill
[1.5.2.3.6.3.2.4.6]
b. Abt 1760 d. Aug 1850
9
Dr Elisha Noyes Sill
[1.5.2.3.6.3.2.4.7]
b. 1761 d. 24 May 1845
9
Jabez Sill, Jr
[1.5.2.3.6.3.2.4.8]
b. 6 Mar 1763 d. 29 Jul 1838
9
Amasa Sill
[1.5.2.3.6.3.2.4.9]
b. 8 Jan 1767 d. 1772
9
Sarah Sill
[1.5.2.3.6.3.2.4.10]
b. 11 Oct 1770 d. 1779
8
William Noyes
[1.5.2.3.6.3.2.5]
b. 1735 d. 11 Feb 1807
Eunice Marvin
b. 2 Dec 1735 d. 5 Apr 1816
9
John Noyes
[1.5.2.3.6.3.2.5.1]
b. 18 Dec 1756 d. 1808
9
Captain Joseph Noyes
[1.5.2.3.6.3.2.5.2]
b. 1758 d. 1820
9
William Noyes
[1.5.2.3.6.3.2.5.3]
b. 30 Oct 1760 d. 23 Dec 1834
9
Matthew Noyes
[1.5.2.3.6.3.2.5.4]
b. 26 Feb 1764 d. 25 Sep 1839
7
Ruth Noyes
[1.5.2.3.6.3.3]
b. 6 Jan 1680 d. 5 May 1774
James Wadsworth
b. 1677 d. 1756
8
James Wadsworth
[1.5.2.3.6.3.3.1]
b. Abt 1700 d. 1777
Abigail Penfield
b. 22 Dec 1704 d. 1748
9
James Wadsworth
[1.5.2.3.6.3.3.1.1]
b. 8 Jul 1730 d. 22 Sep 1817
9
John Noyes Wadsworth
[1.5.2.3.6.3.3.1.2]
b. 1732 d. 1786
9
Ruth Wadsworth
[1.5.2.3.6.3.3.1.3]
b. 1743 d. 20 Jun 1813
Caleb Atwater
b. 7 Sep 1741 d. 19 Dec 1831
10
Anne Atwater
[1.5.2.3.6.3.3.1.3.1]
b. 17 Nov 1765
10
Joshua Atwater
[1.5.2.3.6.3.3.1.3.2]
b. Abt 1766
10
James Wadsworth Atwater
[1.5.2.3.6.3.3.1.3.3]
b. 30 Jun 1777 d. 30 Oct 1777
10
Abigail Atwater
[1.5.2.3.6.3.3.1.3.4]
b. 3 Dec 1778 d. 3 Sep 1834
10
Catharine Atwater
[1.5.2.3.6.3.3.1.3.5]
b. Abt 1780
10
Catherine "Kate" Atwater
[1.5.2.3.6.3.3.1.3.6]
b. 25 May 1781
10
Ruth Atwater
[1.5.2.3.6.3.3.1.3.7]
b. 11 Apr 1788 d. 2 Nov 1877
7
Sarah Noyes
[1.5.2.3.6.3.4]
b. 1682 d. 16 Aug 1756
Captain Timothy Mather
b. 20 Mar 1681 d. 25 Jul 1755
8
Timothy Mather
[1.5.2.3.6.3.4.1]
b. 9 Oct 1711
8
Joseph Mather
[1.5.2.3.6.3.4.2]
b. 23 Feb 1713 d. 5 Feb 1778
8
Ruth Mather
[1.5.2.3.6.3.4.3]
b. 3 Dec 1715 d. 4 Dec 1790
8
Catharine Mather
[1.5.2.3.6.3.4.4]
b. 1717 d. 4 Dec 1799
8
Moses Mather
[1.5.2.3.6.3.4.5]
b. 1718 d. 21 Sep 1806
7
John Noyes
[1.5.2.3.6.3.5]
b. 21 Jan 1688 d. 14 Feb 1755
Jane Dole
b. 23 Jan 1692 d. 14 Feb 1755
8
Josiah Noyes
[1.5.2.3.6.3.5.1]
b. 8 Sep 1712 d. 18 Feb 1796
8
Dorothy Noyes
[1.5.2.3.6.3.5.2]
b. 9 Apr 1715 d. 19 Mar 1798
8
Hannah Noyes
[1.5.2.3.6.3.5.3]
b. 6 Jul 1720 d. Bef Dec 1761
8
Jane Noyes
[1.5.2.3.6.3.5.4]
b. 8 Jan 1722
8
Oliver Noyes
[1.5.2.3.6.3.5.5]
b. 19 Mar 1724 d. 30 Apr 1725
8
Amos Noyes
[1.5.2.3.6.3.5.6]
b. 29 Jul 1728 d. 1752
8
Lieutenant colonel Peter Noyes
[1.5.2.3.6.3.5.7]
b. 3 Dec 1731 d. Aug 1796
6
John Noyes
[1.5.2.3.6.4]
b. 4 Jun 1649 d. 9 Nov 1678
Sarah Oliver
b. 7 Nov 1643 d. 19 Mar 1707
7
Sarah Noyes
[1.5.2.3.6.4.1]
b. 20 Aug 1672
7
John Noyes
[1.5.2.3.6.4.2]
b. 4 Nov 1674 d. 15 Mar 1749
Susanna Edwards
b. 29 Oct 1676
8
John Noyes
[1.5.2.3.6.4.2.1]
b. 17 Dec 1699 d. 1699
8
Sarah Noyes
[1.5.2.3.6.4.2.2]
b. 31 Mar 1701 d. 24 Aug 1702
8
Mary Noyes
[1.5.2.3.6.4.2.3]
b. 30 Oct 1703
8
Susanna Noyes
[1.5.2.3.6.4.2.4]
b. 15 Jun 1705
8
John Noyes
[1.5.2.3.6.4.2.5]
b. 26 Jun 1706 d. 26 Jun 1706
8
Sarah Noyes
[1.5.2.3.6.4.2.6]
b. 18 Sep 1712
8
Abigail Noyes
[1.5.2.3.6.4.2.7]
b. 21 May 1716 d. 12 Jun 1737
8
John Noyes
[1.5.2.3.6.4.2.8]
b. 8 Aug 1718
7
Dr Oliver Noyes
[1.5.2.3.6.4.3]
b. 1675 d. 16 Mar 1720
6
Thomas Noyes
[1.5.2.3.6.5]
b. 10 Aug 1648 d. 24 Apr 1730
Elizabeth Greenleaf
b. 5 Apr 1660 d. 30 Apr 1702
7
Moses Noyes
[1.5.2.3.6.5.1]
b. 29 Jan 1692 d. 1775
7
Mary Noyes
[1.5.2.3.6.5.2]
b. 8 Sep 1686 d. 1758
7
Parker Noyes
[1.5.2.3.6.5.3]
b. 29 Oct 1661 d. Bef 1710
7
Judith Noyes
[1.5.2.3.6.5.4]
b. Abt 1692 d. 30 Sep 1790
7
Thomas Noyes
[1.5.2.3.6.5.5]
b. 2 Oct 1679 d. 10 Jul 1753
7
Joseph Noyes
[1.5.2.3.6.5.6]
b. Abt 1686 d. 3 May 1750
7
Stephen Noyes
[1.5.2.3.6.5.7]
b. 6 Jul 1686
7
Elizabeth Noyes
[1.5.2.3.6.5.8]
b. 19 Feb 1684
7
Rebecca Noyes
[1.5.2.3.6.5.9]
b. 19 Apr 1700
6
Rebecca Noyes
[1.5.2.3.6.6]
b. 1 Apr 1651 d. 15 Oct 1719
John Knight
b. 16 Aug 1648 d. 7 Feb 1695
7
Bathsheba Knight
[1.5.2.3.6.6.1]
b. 1671
7
James Knight
[1.5.2.3.6.6.2]
b. 3 Sep 1672 d. Mar 1736
7
Rebecca Knight
[1.5.2.3.6.6.3]
b. 27 Apr 1674 d. Aft 1700
7
Mary Knight
[1.5.2.3.6.6.4]
b. Abt 1674 d. Abt 1725
Stephen Thurston
b. 5 Feb 1674
8
Moses Thurston
[1.5.2.3.6.6.4.1]
b. 19 Jul 1707 d. 12 Oct 1756
8
John Thurston
[1.5.2.3.6.6.4.2]
b. 29 Aug 1709 d. 28 Apr 1773
8
Rebecca Thurston
[1.5.2.3.6.6.4.3]
b. 1711
8
Robert Thurston
[1.5.2.3.6.6.4.4]
b. 25 Feb 1713 d. 16 Feb 1752
8
Daniel Thurston
[1.5.2.3.6.6.4.5]
b. 27 Aug 1714 d. 16 Feb 1737
8
Mary Thurston
[1.5.2.3.6.6.4.6]
b. 2 Jun 1716 d. 12 Oct 1775
8
Nathanial Thurston
[1.5.2.3.6.6.4.7]
b. 12 Jul 1718 d. 12 Oct 1775
8
Stephen Thurston
[1.5.2.3.6.6.4.8]
b. Abt 1720 d. 27 Nov 1732
8
Mehitable Thurston
[1.5.2.3.6.6.4.9]
b. 1721
7
Sarah Knight
[1.5.2.3.6.6.5]
b. 10 Dec 1675 d. 16 Aug 1690
7
John Knight
[1.5.2.3.6.6.6]
b. 3 Apr 1676 d. Aft 1725
7
Nathaniel Knight
[1.5.2.3.6.6.7]
b. 22 Dec 1688 d. 29 Oct 1754
7
Joseph Knight
[1.5.2.3.6.6.8]
b. 9 Oct 1683 d. 31 Jan 1746
7
Elizabeth Knight
[1.5.2.3.6.6.9]
b. 5 Jul 1696 d. 5 Jul 1774
6
William Noyes
[1.5.2.3.6.7]
b. 22 Sep 1653 d. 10 Mar 1744
Sarah Cogswell
b. 3 Feb 1668 d. Bef 1716
7
Moses Noyes
[1.5.2.3.6.7.1]
b. 27 Jan 1693 d. 16 Feb 1693
7
Mary Noyes
[1.5.2.3.6.7.2]
b. 24 May 1699 d. 16 Dec 1703
7
Sarah Noyes
[1.5.2.3.6.7.3]
b. 10 May 1691 d. 3 Dec 1703
7
John Noyes
[1.5.2.3.6.7.4]
b. 27 Jul 1686 d. 4 Jan 1772
7
Seusanah Noyes
[1.5.2.3.6.7.5]
b. Abt 1687 d. 6 Apr 1754
7
Parker Noyes
[1.5.2.3.6.7.6]
b. 17 Jan 1704 d. 22 Sep 1784
6
Sarah Noyes
[1.5.2.3.6.8]
b. 21 Mar 1655 d. 20 May 1697
John Hale
b. 24 Mar 1675 d. 4 Apr 1761
7
James Hale
[1.5.2.3.6.8.1]
b. 14 Oct 1685 d. 22 Nov 1742
Sarah Hathaway
b. Abt 1686
8
John Hale
[1.5.2.3.6.8.1.1]
b. 19 Apr 1715 d. 7 Jun 1738
8
James Hale, Jr
[1.5.2.3.6.8.1.2]
b. 9 Feb 1716 d. Bef 1774
7
John Hale
[1.5.2.3.6.8.2]
b. 24 Jun 1686 d. 29 Nov 1739
7
Samuel Hale
[1.5.2.3.6.8.3]
b. 13 Aug 1687 d. 29 May 1724
7
Joanna Hale
[1.5.2.3.6.8.4]
b. 15 Jun 1689 d. 1713
7
Robert Hale
[1.5.2.3.6.8.5]
b. 3 Nov 1688 d. 1719
7
John Hale
[1.5.2.3.6.8.6]
b. 24 Dec 1692
5
Mary Noyes
[1.5.2.3.7]
b. Abt 1610 d. 3 Aug 1696
5
John Noyes
[1.5.2.3.8]
b. 1612 d. Aft 24 Jul 1660
5
Ann Noyes
[1.5.2.3.9]
b. 1613 d. 16 Oct 1671
Thomas Kent
b. 13 Jun 1609 d. 1 May 1658
6
Samuel Kent
[1.5.2.3.9.1]
b. Abt 1634 d. 2 Feb 1691
6
Thomas Kent
[1.5.2.3.9.2]
b. Abt 1634 d. 14 Aug 1691
6
Josiah Kent
[1.5.2.3.9.3]
b. Abt 1636 d. 19 May 1725
5
Nicholas Noyes
[1.5.2.3.10]
b. 23 Nov 1614 d. 23 Nov 1701
Mary Cutting
b. Apr 1622 d. 28 Dec 1701
6
Margerie Moyes
[1.5.2.3.10.1]
b. 1 Oct 1639
John S Kyle
b. Abt 1635
7
James Kyle
[1.5.2.3.10.1.1]
b. Abt 1660 d. 1735
Isabel Dickson
b. 1660
8
Thomas Kyle
[1.5.2.3.10.1.1.1]
b. 1683
8
John Kyle
[1.5.2.3.10.1.1.2]
b. Abt 1684 d. 1759
8
Mary Kyle
[1.5.2.3.10.1.1.3]
b. 1685 d. 20 Jan 1757
8
James Kyle
[1.5.2.3.10.1.1.4]
b. Abt 1686 d. Aft 1760
8
Robert Kyle
[1.5.2.3.10.1.1.5]
b. Abt 1690 d. 1783
7
Mark Kyle
[1.5.2.3.10.1.2]
b. Abt 1665 d. Aft 1692
Margaret Sheivell
c. 17 Mar 1667
8
William Kyle
[1.5.2.3.10.1.2.1]
b. 18 May 1690
8
Thomas Kyle
[1.5.2.3.10.1.2.2]
b. 5 Apr 1691
8
John Kyle
[1.5.2.3.10.1.2.3]
b. 7 Jul 1692
8
Isabel Kyle
[1.5.2.3.10.1.2.4]
b. Abt 11 Dec 1692 d. Bef 20 Nov 1713
6
Hannah Noyes
[1.5.2.3.10.2]
b. 13 Oct 1643 d. 5 Jan 1705
6
John Noyes
[1.5.2.3.10.3]
b. 20 Jan 1645
Mary E Poore
b. 21 Mar 1651 d. 1716
7
Samuel Noyes
[1.5.2.3.10.3.1]
b. 5 Feb 1690 d. 6 Nov 1729
Hannah Poore
b. 19 Jul 1692 d. 6 Nov 1729
8
John Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1]
b. 7 Apr 1720 d. 30 May 1770
Abigail Poore
b. 6 Jun 1721 d. 19 Mar 1814
9
Benjamin Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1]
b. 29 Apr 1742 d. 16 Mar 1811
Hannah Thompson
b. 2 Dec 1744 d. 4 Nov 1828
10
Abigail Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.1]
b. 11 Nov 1766 d. 27 Jul 1857
James Buntin
b. 18 Dec 1765 d. 13 Jan 1840
11
James Buntin
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.1.1]
b. 20 Jun 1788
11
Hannah Buntin
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.1.2]
b. 1 Nov 1790
11
Jane Buntin
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.1.3]
b. 3 Jun 1792
11
Benjamin Buntin
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.1.4]
b. 2 Aug 1795
11
John Buntin
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.1.5]
b. 29 Jun 1797
11
Abagail Buntin
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.1.6]
b. 27 Dec 1799
11
Abigail Buntin
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.1.7]
b. 1800 d. 7 Jul 1862
Benjamin Noyes
b. 17 Nov 1799 d. 17 Sep 1882
12
Betsey Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.1.7.1]
b. 27 Aug 1801
12
Mary Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.1.7.2]
b. 6 Jan 1803
12
Sarah Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.1.7.3]
b. 9 Jan 1804
12
Hiram Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.1.7.4]
b. 13 Mar 1806
12
Hannah Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.1.7.5]
b. 28 Nov 1807
12
John Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.1.7.6]
b. 3 Jun 1809
12
Eliza Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.1.7.7]
b. 24 Sep 1811
12
Moses Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.1.7.8]
b. 23 Mar 1813
12
Jane L Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.1.7.9]
b. 1 May 1816
12
Andrew Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.1.7.10]
b. 3 Mar 1823 [
=>
]
12
Benjamin Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.1.7.11]
b. Abt Aug 1827 d. 26 Feb 1865 [
=>
]
12
Saluria L Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.1.7.12]
b. 17 Dec 1827
12
Sarah Moyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.1.7.13]
b. 1831 d. 1897
11
Sally Buntin
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.1.8]
b. 24 Feb 1802
11
Andrew Buntin
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.1.9]
b. 20 Feb 1806
11
Mary Jane Buntin
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.1.10]
b. 1808
10
Clement Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.2]
b. 20 Dec 1768 d. 15 Jun 1836
10
Hannah Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.3]
b. 18 Jan 1771 d. 28 Mar 1858
10
Thomas Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.4]
b. 8 Mar 1773 d. 13 Aug 1833
Sarah "Sally" Hemphill
b. 25 Apr 1773 d. 19 Aug 1831
11
Mary Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.4.1]
b. 6 Jan 1793 d. 10 Sep 1832
11
Polly Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.4.2]
b. 8 Feb 1796 d. 26 Jan 1800
11
James Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.4.3]
b. 24 Sep 1797
11
Benjamin Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.4.4]
b. 17 Nov 1799 d. 17 Sep 1882
Abigail Buntin
b. 1800 d. 7 Jul 1862
12
Betsey Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.4.4.1]
b. 27 Aug 1801
12
Mary Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.4.4.2]
b. 6 Jan 1803
12
Sarah Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.4.4.3]
b. 9 Jan 1804
12
Hiram Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.4.4.4]
b. 13 Mar 1806
12
Hannah Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.4.4.5]
b. 28 Nov 1807
12
John Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.4.4.6]
b. 3 Jun 1809
12
Eliza Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.4.4.7]
b. 24 Sep 1811
12
Moses Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.4.4.8]
b. 23 Mar 1813
12
Jane L Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.4.4.9]
b. 1 May 1816
12
Andrew Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.4.4.10]
b. 3 Mar 1823 [
=>
]
12
Benjamin Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.4.4.11]
b. Abt Aug 1827 d. 26 Feb 1865 [
=>
]
12
Saluria L Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.4.4.12]
b. 17 Dec 1827
12
Sarah Moyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.4.4.13]
b. 1831 d. 1897
11
Betsey H Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.4.5]
b. 27 Apr 1801
Levi Mudgett
b. 10 Apr 1801 d. 10 Apr 1831
12
William Thomas Mudgett
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.4.5.1]
b. 17 Apr 1831
11
Sarah H Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.4.6]
b. 9 Jun 1804
+
Caburn Kendall
11
Hiram Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.4.7]
b. 13 Mar 1806 d. 10 Feb 1849
+
Lois Terry
b. 25 Jul 1811 d. 2 Jun 1839
11
Hannah Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.4.8]
b. 28 Nov 1807 d. 2 Oct 1840
11
John Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.4.9]
b. 3 Jun 1809
Fannie Whitney
b. 1810
12
Sarah Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.4.9.1]
b. 1843
12
George P Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.4.9.2]
b. 30 Jun 1845
12
Books H Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.4.9.3]
b. 26 Dec 1855 [
=>
]
11
Moses K Moses
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.4.10]
b. 23 Mar 1813 d. 22 Dec 1893
Mercy W White
b. Abt 1816
12
George K Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.4.10.1]
b. 17 Oct 1839
12
Elizabeth J Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.4.10.2]
b. 30 Aug 1841
12
Rosanna F Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.4.10.3]
b. 16 May 1846
12
Juniata G Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.4.10.4]
b. 5 Dec 1848
12
Alfaretta L Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.4.10.5]
b. 5 Dec 1848
11
Eliza Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.4.11]
b. 24 Sep 1814 d. 13 Sep 1841
11
Jane L Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.4.12]
b. 1 May 1818
+
Moors Patee
10
Judith Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.5]
b. 15 Oct 1777 d. 28 May 1868
Robert Thompson
b. 1774
11
Mary Thompson
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.5.1]
b. 7 Dec 1799 d. 19 Feb 1879
Jeremiah Hall Wilkins
b. 25 Dec 1791 d. 1864
12
Sarah Wilkins
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.5.1.1]
b. 28 Feb 1818 d. 11 Oct 1887 [
=>
]
12
Charles Wilkins
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.5.1.2]
b. 21 Dec 1819 d. 2 Nov 1820
12
Alanson Wilkins
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.5.1.3]
b. 31 Mar 1822 d. 16 Jun 1863
12
Sophia Wilkins
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.5.1.4]
b. 5 Aug 1824 d. 24 Nov 1869 [
=>
]
12
Francis Wilkins
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.5.1.5]
b. 3 Apr 1826 d. 15 Mar 1901
12
George Wilkins
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.5.1.6]
b. 29 Dec 1827 d. 22 Jul 1829
12
Caroline Wilkins
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.5.1.7]
b. 15 Sep 1831 d. 15 Sep 1857
12
Thompson Wilkins
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.5.1.8]
b. 27 Dec 1832 d. 3 Oct 1833
12
Henry Wilkins
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.5.1.9]
b. 7 Jul 1836
12
Charlotte Wilkins
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.5.1.10]
b. 27 Jun 1838 d. 13 Jun 1840
12
Harriet Wilkins
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.5.1.11]
b. 23 Mar 1840
12
Mary Esther Wilkins
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.5.1.12]
b. 23 Mar 1840
12
Joseph Wilkins
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.5.1.13]
b. 24 May 1844
12
Harriet Wilkins
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.5.1.14]
b. Apr 1848
11
Polly Thompson
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.5.2]
b. 7 Dec 1799 d. 19 May 1879
11
Robert Thompson
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.5.3]
b. 24 Apr 1803
10
Mary Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.6]
b. 11 Jun 1779 d. 24 May 1858
+
Martin
10
Phoebe Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.7]
b. 10 Sep 1784 d. 11 Sep 1880
William Taggart
b. 19 Mar 1781 d. 30 Apr 1861
11
William Taggart
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.7.1]
b. Abt 1803
11
Henry Taggart
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.7.2]
b. Abt 1805
11
Eliza Taggart
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.7.3]
b. 8 Mar 1807 d. 13 Apr 1862
James B Colby
b. 21 Nov 1808 d. 15 Nov 1876
12
Julia Ann Colby
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.7.3.1]
b. 11 Nov 1835 [
=>
]
12
Aaron Colby
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.7.3.2]
b. 26 Jun 1838 d. 7 Oct 1891 [
=>
]
12
Jane Colby
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.7.3.3]
b. 15 May 1841 d. 17 Jul 1844
12
Mary B Colby
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.7.3.4]
b. 16 May 1844
11
Leonard Taggart
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.7.4]
b. Abt 1809
Nancy J Green
b. 27 Sep 1820 d. 17 Sep 1893
12
James G Taggart
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.7.4.1]
b. Abt 1842
12
James Leonard Taggert
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.7.4.2]
b. 25 Dec 1846 d. 13 Jun 1932 [
=>
]
11
Jane Taggart
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.7.5]
b. 1812 d. 2 Apr 1898
Samuel Rogers Green
b. 22 Mar 1806 d. 21 Nov 1877
12
Benjamin T Green
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.7.5.1]
b. 6 Jan 1837 d. 20 Nov 1923
12
Charles Shattuck Green
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.7.5.2]
b. 19 Oct 1840 d. 7 May 1911
12
Henry T Green
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.7.5.3]
b. 23 Sep 1844 d. 12 Sep 1849
12
John B Green
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.7.5.4]
b. 21 May 1845
11
Mary Taggart
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.7.6]
b. Abt 1813
10
Benning Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.8]
b. 9 Dec 1780 d. 2 Nov 1814
Hannah Story
b. 6 Sep 1784 d. 24 Nov 1857
11
Benjamin Abbott Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.8.1]
b. 10 Jul 1809 d. 1892
Jane Roach
b. 1806
12
Benjamin F Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.8.1.1]
b. 15 Jun 1836 d. 22 Dec 1833
12
George W Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.8.1.2]
b. 19 Apr 1842 d. Abt 1907 [
=>
]
+
Mary Fowler
b. Abt 1814
11
Jeremiah Story Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.8.2]
b. 7 Jun 1811 d. 16 Jan 1894
Caroline Bates
b. 16 May 1812
12
Charles Henry Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.8.2.1]
b. 29 Aug 1834
12
Annie Eliza Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.8.2.2]
b. 24 Sep 1839
11
Hannah Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.8.3]
b. 3 Aug 1813
John Parker
b. 1813 d. 4 Sep 1836
12
John Parker
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.8.3.1]
b. 29 Aug 1833 d. 17 Aug 1836
12
Francis Parker
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.8.3.2]
b. 20 Jun 1835
10
Jane Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.9]
b. 10 Aug 1782 d. 21 May 1840
10
Elizabeth Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.10]
b. 10 Aug 1782
+
Samuel Story
10
Sally Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.11]
b. 21 Jan 1786
Leonard Pratt
b. 7 Oct 1781
11
Eliza Pratt
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.11.1]
b. 11 Feb 1809
11
Child Pratt
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.11.2]
b. Abt 1811
11
Child Pratt
[1.5.2.3.10.3.1.1.1.11.3]
b. Abt 1813
9
John Noyes, Jr
[1.5.2.3.10.3.1.1.2]
b. 13 Mar 1744 d. 7 Oct 1825
Mary Fowler
b. 22 Mar 1744 d. 14 Jan 1826
10
Abigail Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.1]
b. 28 Jan 1764 d. 1 Feb 1842
+
James Moore
b. 1760 d. 27 Aug 1835
10
John P Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.2]
b. 27 Jun 1766
Martha Haseltine
b. Abt 1767
11
Betsey Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.2.1]
b. 1789
11
John Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.2.2]
b. 1791
11
Ruth Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.2.3]
b. 1793
+
Timothy Hammond
11
Daughter Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.2.4]
b. 1795
11
Mary Abigal Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.2.5]
b. 24 Sep 1799 d. 16 Nov 1872
Winthrop Folsom
b. 27 Jan 1794 d. 18 Sep 1856
12
Asahel Blake Folsom
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.2.5.1]
b. Abt 1816 d. 16 Oct 1848 [
=>
]
12
Gilman Folsom
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.2.5.2]
b. 7 Apr 1818 d. 15 Jul 1872 [
=>
]
12
Susan Pickering Folsom
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.2.5.3]
b. Abt 1825 d. 22 Oct 1895 [
=>
]
12
Mary D Folsom
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.2.5.4]
b. Abt 1832
11
Matilda Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.2.6]
b. 25 Sep 1802
+
Job Willis
10
Sarah Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.3]
b. 17 Dec 1768 d. 28 Dec 1854
Ballard Hazelton
b. 4 Sep 1769 d. 1836
11
Peter Hazelton
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.3.1]
b. 7 Jan 1793 d. 22 Dec 1846
Sarah "Sally" Pearse
b. 1 Dec 1787 d. 14 Jan 1852
12
Nancy Jane Hazelton
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.3.1.1]
b. 24 Sep 1812 d. 25 Dec 1891 [
=>
]
12
Pearse Richardson Hazelton
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.3.1.2]
b. 27 Feb 1821 d. 8 Mar 1878
12
Aaron Carter Hazelton
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.3.1.3]
b. 22 Apr 1822 d. 10 Mar 1906
12
Peter Clark Hazelton
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.3.1.4]
b. 1825 d. Aug 1845
12
Mary Ann Hazelton
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.3.1.5]
b. 1827 d. 1857
12
Brooks Bowman Hazelton
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.3.1.6]
b. 10 May 1829 d. 10 Dec 1899
12
Jeanette Hazelton
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.3.1.7]
b. 10 Mar 1834 d. 7 Oct 1881
11
John Hazelton
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.3.2]
b. 12 Oct 1794
11
Nathaniel Hazelton
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.3.3]
b. 2 Dec 1797
11
Joseph Hazelton
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.3.4]
b. 29 Nov 1799
11
Eliza Hazelton
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.3.5]
b. 5 Dec 1802
11
Mary Ann Hazelton
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.3.6]
b. 21 May 1805 d. 7 Apr 1868
11
Emily Hazelton
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.3.7]
b. 3 Aug 1807
11
Sally Stickney Hazelton
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.3.8]
b. 16 Jul 1809
11
George Washington Hazelton
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.3.9]
b. 18 Feb 1812 d. 27 Aug 1864
11
Nancy Jane Hazelton
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.3.10]
b. 24 Sep 1812 d. 25 Dec 1891
Alexander Cummings
b. 1808
12
Lelia Luella Hazelton
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.3.10.1]
b. 24 Feb 1850 d. 3 Sep 1929 [
=>
]
10
Mary Polly Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.4]
b. 13 May 1772
Ebeneser Frye
b. 15 Apr 1771 d. Dec 1822
11
Ebenezer Frye
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.4.1]
b. 1795 d. 4 Apr 1823
11
Jedediah Frye
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.4.2]
b. 1797 d. 1817
11
Elizabeth Frye
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.4.3]
b. 1799 d. 1814
11
John B Frye
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.4.4]
b. 14 Apr 1803 d. 18 Oct 1879
Hannah Blake
b. Abt 1807
12
Mary Elizabeth Frye
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.4.4.1]
b. 5 Nov 1830 d. 13 Dec 1855
12
Moses Blake Frye
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.4.4.2]
b. 9 Aug 1832 d. 13 May 1858
12
Huldah Frye
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.4.4.3]
b. 14 Oct 1834
12
Hannah Frye
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.4.4.4]
b. 24 Aug 1837 d. 13 Dec 1855
12
Eben Frye
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.4.4.5]
b. 22 Nov 1838
12
Lucy Frye
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.4.4.6]
b. 29 Aug 1842 [
=>
]
12
Calista C Frye
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.4.4.7]
b. 28 May 1845 [
=>
]
12
Robie Frye
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.4.4.8]
b. 18 Jun 1848
11
Nancy R Frye
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.4.5]
b. 1805
William G Whitney
b. Abt 1801
12
James K Whitney
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.4.5.1]
b. 1836
12
Joseph G Whitney
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.4.5.2]
b. 1838 d. 14 Dec 1879
12
Susan Maria Whitney
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.4.5.3]
b. 1841
11
Hulda E Frye
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.4.6]
b. 12 Jun 1807
10
Abner Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.5]
b. 26 Jan 1775 d. 14 Jul 1865
Polly Robertson
b. 15 Dec 1778
11
Mahala Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.5.1]
b. 11 Nov 1802
Aaron Critchett
b. Abt 26 Jan 1800 d. 28 Aug 1887
12
Susan Jane Critchett
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.5.1.1]
b. 11 Mar 1831 [
=>
]
12
Charles E Critchett
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.5.1.2]
b. 1835 d. 23 Jun 1902
11
Harriet Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.5.2]
b. 7 Jul 1805 d. 9 Dec 1883
John Kimball
b. 16 Feb 1807 d. 9 Dec 1883
12
Charles Kimball
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.5.2.1]
b. 25 Jan 1830 d. 1 Sep 1884
12
Melissia Ann Kimball
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.5.2.2]
b. 10 Sep 1832 d. 3 Aug 1875
12
Harriet Augusta Kimball
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.5.2.3]
b. 20 Dec 1836 d. 17 Oct 1885
12
John Noyes Kimball
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.5.2.4]
b. 9 Sep 1845 d. 7 Aug 1890 [
=>
]
12
Sarah Jane Kimball
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.5.2.5]
b. 20 Oct 1847
11
Albert Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.5.3]
b. 3 Dec 1806 d. 7 Oct 1892
Esther Williams
d. 13 Jul 1889
12
Eudora F Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.5.3.1]
b. 1846 d. 30 Oct 1868
12
Mary Esther Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.5.3.2]
b. 1868 d. 1870
11
Margaret Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.5.4]
b. 14 Oct 1808 d. 3 Mar 1895
William Morgan
b. 17 Apr 1812 d. 18 May 1860
12
Warren Morgan
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.5.4.1]
b. 18 Apr 1838 d. 9 Feb 1904
12
Harriett A Morgan
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.5.4.2]
b. 8 Mar 1841
12
Edmund R Morgan
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.5.4.3]
b. 6 Mar 1843
12
William Morgan
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.5.4.4]
b. 28 Mar 1846
12
Emily Morgan
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.5.4.5]
b. 6 Jul 1847 d. 1 Sep 1868
12
Mary J Morgan
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.5.4.6]
b. 26 Jul 1850
12
Ella Morgan
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.5.4.7]
b. 8 Apr 1859
11
John Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.5.5]
b. Abt 1813
11
Nealy Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.5.6]
b. 27 Aug 1817
10
Martha Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.6]
b. Abt 1776 d. 25 Apr 1868
Jedediah Holt
b. 12 Aug 1774 d. 1850
11
Lucinda Holt
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.6.1]
b. 18 May 1805
Warren Flint
b. Abt 1803
12
Tamar Flint
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.6.1.1]
b. Abt 1826 d. 6 Mar 1833
12
Warren Byron Flint
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.6.1.2]
b. 25 Mar 1831
12
Alvan Sawyer Flint
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.6.1.3]
b. 15 Dec 1832
12
Lucy Sawyer Flint
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.6.1.4]
b. 9 Sep 1834
12
George Henry Flint
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.6.1.5]
b. 22 Aug 1836 d. 10 Jul 1905 [
=>
]
12
Benjamin Franklin Flint
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.6.1.6]
b. 1 Jul 1838
12
Forest Newton Flint
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.6.1.7]
b. 13 Jan 1842
12
Ellen Viola Flint
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.6.1.8]
b. 12 Feb 1844
12
Viola M Flint
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.6.1.9]
b. 6 Dec 1850
11
Mary Holt
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.6.2]
b. 18 May 1805
Joshua Burley
b. 28 Mar 1803
12
Mary J Burley
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.6.2.1]
b. 10 Dec 1827 d. 15 Sep 1904 [
=>
]
12
Elizabeth Burley
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.6.2.2]
b. 1832
12
William F Burley
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.6.2.3]
b. 1841
12
Emma A Burley
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.6.2.4]
b. Feb 1846 [
=>
]
12
Ella M Burley
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.6.2.5]
b. 6 Apr 1848 [
=>
]
12
George J Burley
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.6.2.6]
b. 1851
11
Son Holt
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.6.3]
b. Abt 1810
11
Daniel Holt
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.6.4]
b. 15 Jun 1815 d. 15 Aug 1873
Sarah A Sanborn
b. 1 Jun 1813
12
Francis B Holt
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.6.4.1]
b. Jun 1837
12
Lizzie Holt
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.6.4.2]
b. 1839
12
George W Holt
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.6.4.3]
b. Feb 1842
12
Charles Albert Holt
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.6.4.4]
b. 20 Mar 1848
12
Josephine A Holt
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.6.4.5]
b. 29 Mar 1851 d. 18 Apr 1858
11
John Holt
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.6.5]
b. 26 Dec 1812 d. Aft 1861
Letitia Blanchard
b. 1814
12
Esther J Holt
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.6.5.1]
b. 29 Nov 1848
12
Ann Jennette Holt
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.6.5.2]
b. Oct 1858
11
Franklin Holt
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.6.6]
b. 8 Jan 1818 d. Aft 1861
Eliza Sanborn
b. Abt 1820 d. 5 Dec 1880
12
Henry Harrison Holt
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.6.6.1]
b. 28 Feb 1843
12
John F Holt
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.6.6.2]
b. 15 Jan 1848 d. 29 Jan 1848
12
Ellen M Holt
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.6.6.3]
b. 18 May 1850
12
Son Holt
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.6.6.4]
b. 5 May 1852
12
Lafayette Holt
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.6.6.5]
b. 2 Sep 1855
10
Jacob Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.7]
b. 6 Jun 1777
+
Polly Colby
b. 1780
10
Nancy Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.8]
b. 29 Jun 1779
John Robertson
b. Abt 1777
11
Nancy Robertson
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.8.1]
b. 22 Dec 1808 d. 8 Mar 1877
Samuel Dakin
b. 23 May 1812 d. 31 Aug 1844
12
John Robertson Dakin
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.8.1.1]
b. 19 Jul 1843
10
Isaac Chamberlain Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9]
b. 28 Nov 1781 d. 12 May 1860
Polly Noyes
b. Abt 1782 d. 25 Apr 1841
11
George W Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.1]
b. 25 Jan 1805 d. 7 Jun 1874
Caroline Avery
b. Abt 1805
12
Isaac D Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.1.1]
b. 16 Jul 1826 [
=>
]
12
George W Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.1.2]
b. 7 Jun 1828 d. 27 Oct 1857 [
=>
]
12
Caroline Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.1.3]
b. 27 Feb 1830 d. 24 Feb 1860
12
Hannah Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.1.4]
b. 18 May 1833 d. 26 Apr 1860
12
Thomas Alonzo Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.1.5]
b. 18 Nov 1837 d. 2 Aug 1923 [
=>
]
12
John Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.1.6]
b. 9 Apr 1841 d. 21 Sep 1879
12
Olive Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.1.7]
b. 31 Jul 1843 d. Feb 1878
12
Dennis S Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.1.8]
b. 1 Nov 1852 d. 4 Dec 1865
11
Edwin Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.2]
b. 9 Nov 1806 d. 1894
+
Sophie Richards
11
Mary N Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.3]
b. 18 Jan 1809 d. 2 Apr 1900
Thomas Adams
c. 25 Aug 1806 d. 29 Apr 1875
12
Sophronia Adams
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.3.1]
b. 1836 [
=>
]
12
Edwin L Adams
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.3.2]
b. 1840
12
Melissa L Adams
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.3.3]
b. 1842 [
=>
]
12
Silvia J Adams
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.3.4]
b. 1845 [
=>
]
12
Melvina Adams
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.3.5]
b. 19 Jul 1849 d. 30 Apr 1912 [
=>
]
12
Melvin Adams
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.3.6]
b. 1852 [
=>
]
11
Louisa Noves
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.4]
b. 14 Mar 1811 d. 1876
William Deane
b. 26 Mar 1801
12
Mary Gibbs Deane
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.4.1]
b. 15 Aug 1830 [
=>
]
12
Cyrus Deane
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.4.2]
b. 9 Mar 1834 d. 17 Dec 1908 [
=>
]
12
William Penn Deane
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.4.3]
b. 24 Jul 1842 [
=>
]
12
Louisa Matilda Deane
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.4.4]
b. 4 Jul 1846 d. Aft 1873 [
=>
]
12
Alma Llewella Deane
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.4.5]
b. 7 Feb 1852
11
Delia Adams Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.5]
b. 10 Sep 1813
Joseph Avery
b. 1810
12
Adelia E Avery
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.5.1]
b. 12 May 1834
11
Rachel Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.6]
b. Abt 1817 d. 1838
11
Isaac C Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.7]
b. 27 Oct 1819 d. 12 Aug 1891
11
Nancy J Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.8]
b. 15 Jan 1823
11
Sophronia G Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.9]
b. 15 Jan 1824 d. 1871
Charles M Lufkin
b. 15 Jun 1824 d. 31 Aug 1906
12
Ellen Lufkin
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.9.1]
b. Abt 1850
12
Horace Greeley Lufkin
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.9.2]
b. Abt 1853
12
Charles Forrest Lufkin
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.9.3]
b. Aug 1857 [
=>
]
12
Adela "Adda" Lufkin
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.9.4]
b. Abt 1858 d. Abt 1882
12
Lucien S Lufkin
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.9.5]
b. Abt 1861 d. 1863
12
Fannie E Lufkin
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.9.6]
b. Abt 1862 d. 1863
11
Sarah N Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.10]
b. 15 Jan 1826 d. 1905
11
Francis Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.11]
b. 27 Oct 1828 d. 1828
11
Franklin Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.12]
b. 14 May 1829 d. 8 Nov 1896
11
Abigail M Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.13]
b. 1 Jun 1831
11
Charles Morse Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.14]
b. 1 Jun 1831 d. 6 Mar 1921
Helen Elizabeth Greenough
b. 17 Jan 1838 d. 5 Jun 1890
12
Harold Verne Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.14.1]
b. 1859 d. 1909 [
=>
]
12
Franklin Florence Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.14.2]
b. 23 Apr 1861 d. 1935 [
=>
]
12
Charles Warren Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.14.3]
b. 22 Dec 1863 d. 25 Apr 1947 [
=>
]
12
Annie R Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.14.4]
b. Nov 1868 d. 12 Apr 1870
12
Lena Estelle Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.14.5]
b. 1872 d. 8 Mar 1875
12
Clifford Greenough Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.14.6]
b. 18 Oct 1875 d. 5 Oct 1883
11
Flavilla P Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.15]
b. 8 Aug 1833 d. 1901
11
Philander E Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.16]
b. 3 Nov 1835
Elvira M Small
b. 1840
12
John R Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.16.1]
b. 8 Jan 1867 d. 26 Jan 1892
12
Alice L Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.16.2]
b. 7 Mar 1869
12
Florence E Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.16.3]
b. 14 Dec 1870
Lucinda J Huse
b. 1864
12
Reno P Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.16.4]
b. 3 Nov 1890
11
Julia A Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.9.17]
b. 8 Feb 1839 d. 1928
+
William W Jones
b. 1829 d. 1909
10
George Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.10]
b. 15 Feb 1784 d. 1888
Hannah Cotton
b. 2 Feb 1791 d. 13 Oct 1877
11
Thomas Branch Cotton Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.10.1]
b. 3 Jul 1809 d. 18 Mar 1833
11
Frances C Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.10.2]
b. 11 May 1811 d. 1840
11
Nancy Cotton Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.10.3]
b. 27 Feb 1823
+
Lowell Eastman
b. 7 Jan 1817
10
Polly B Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.2.11]
b. 28 Mar 1787
+
Jedediah Holt
b. 1781
9
Samuel Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3]
b. 2 Jul 1746 d. 14 Mar 1812
Hannah Bradley
b. 12 Jul 1742
10
Hannah Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.1]
b. 21 May 1770 d. 5 Sep 1856
+
Robert Lake
10
Lois Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.2]
b. 29 May 1772 d. 2 May 1841
Joshua King
b. 7 Oct 1771 d. 28 Sep 1865
11
Nathaniel King
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.2.1]
b. 5 Nov 1794 d. 14 Feb 1869
Almira Bean
b. 9 Oct 1801 d. 19 Sep 1892
12
Louisa King
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.2.1.1]
b. 21 Nov 1821 d. 23 Dec 1821
12
George Washington King
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.2.1.2]
b. Feb 1822 d. 4 Apr 1822
12
Samuel King
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.2.1.3]
b. 24 Nov 1824 d. 1905 [
=>
]
12
Son King
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.2.1.4]
b. Abt 1826
12
Mary Louisa King
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.2.1.5]
b. 11 Feb 1827 d. 26 Apr 1833
12
Royal King
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.2.1.6]
b. 9 Nov 1837
12
George D King
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.2.1.7]
b. 13 Nov 1839 d. 1892 [
=>
]
12
Abigail King
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.2.1.8]
b. 22 Aug 1841
11
Samuel King
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.2.2]
b. 18 Feb 1796
11
Hannah King
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.2.3]
b. 12 Feb 1798 d. 5 Dec 1839
11
Sally King
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.2.4]
b. 9 Jan 1800
11
Aseneth B King
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.2.5]
b. 25 Oct 1801
+
Ebenezer Ormsby
b. Abt 1794 d. Sep 1850
11
Lois King
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.2.6]
b. 15 Mar 1804 d. 3 Mar 1877
Elias Smith Tuttle
b. 29 Jul 1808 d. 23 Mar 1894
12
Daughter Tuttle
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.2.6.1]
b. 1834
12
Son Tuttle
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.2.6.2]
b. 1834
12
Elias Jefferson Tuttle
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.2.6.3]
b. 28 Aug 1836
12
Mary Ann Tuttle
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.2.6.4]
b. 28 Apr 1840
12
George L Tuttle
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.2.6.5]
b. 8 Aug 1844 d. 9 Nov 1915 [
=>
]
11
James King
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.2.7]
b. 22 Aug 1806
11
John King
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.2.8]
b. Abt 1807 d. 21 Sep 1878
Elizabeth M Noyes
b. 21 Dec 1812 d. 23 Dec 1891
12
Lois Cordelia King
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.2.8.1]
b. 12 Jul 1835 [
=>
]
12
Milton J King
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.2.8.2]
b. 10 May 1839 d. 23 Jun 1867 [
=>
]
12
Lura A King
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.2.8.3]
b. 20 Apr 1841 d. 11 Apr 1933 [
=>
]
12
Almon L King
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.2.8.4]
b. Abt 1843
12
David C King
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.2.8.5]
b. 10 Mar 1847 d. 4 Apr 1925 [
=>
]
12
Aaron B King
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.2.8.6]
b. Abt 1849
11
Mary King
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.2.9]
b. 12 Jul 1810
11
Moses King
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.2.10]
b. 7 Aug 1812
11
Abigail King
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.2.11]
b. 3 Oct 1815
11
Nancy Chambers King
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.2.12]
b. 18 Sep 1818
10
Nathaniel Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.3]
b. 26 Jul 1774
Catherine Dean
b. 19 Dec 1775 d. 13 Jan 1859
11
Hannah Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.3.1]
b. 13 Jul 1800 d. 6 Oct 1801
11
Otis Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.3.2]
b. 18 Aug 1802 d. 23 Jun 1878
Nancy G Cummings
b. Abt 1802 d. 16 Sep 1874
12
Henry Otis Moyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.3.2.1]
b. 29 Jan 1826 d. 10 May 1869 [
=>
]
12
Nancy J Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.3.2.2]
b. Abt 1827 [
=>
]
12
Son Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.3.2.3]
b. 1828
11
Hannah Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.3.3]
b. 17 Mar 1805 d. 31 Oct 1823
11
Elizabeth Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.3.4]
b. 11 Dec 1807 d. 1881
Joel Metcalf Baker
b. 9 Sep 1808 d. 21 May 1878
12
Francis Metcalf Baker
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.3.4.1]
b. 7 May 1833 [
=>
]
12
Henry Bradford Baker
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.3.4.2]
b. 9 Jan 1838
12
Ellen Elizabeth Baker
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.3.4.3]
b. 15 Jan 1848
11
Nathaniel Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.3.5]
b. 10 Feb 1810 d. 12 Nov 1889
+
Sarah Draper
b. 1 Jul 1809 d. 10 Nov 1831
11
Catharine Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.3.6]
b. 20 Dec 1812 d. 1876
11
Mary Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.3.7]
b. 6 Jun 1815 d. 1892
+
Edwin B Knight
b. 1813
11
Lucy Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.3.8]
b. 28 Jan 1818 d. 1856
+
Marcus A Jackson
b. 1816
10
Betsey Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.4]
b. 27 Nov 1775
10
John Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.5]
b. 8 Dec 1777
10
Polly Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6]
b. Abt 1782 d. 25 Apr 1841
Isaac Chamberlain Noyes
b. 28 Nov 1781 d. 12 May 1860
11
George W Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.1]
b. 25 Jan 1805 d. 7 Jun 1874
Caroline Avery
b. Abt 1805
12
Isaac D Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.1.1]
b. 16 Jul 1826 [
=>
]
12
George W Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.1.2]
b. 7 Jun 1828 d. 27 Oct 1857 [
=>
]
12
Caroline Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.1.3]
b. 27 Feb 1830 d. 24 Feb 1860
12
Hannah Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.1.4]
b. 18 May 1833 d. 26 Apr 1860
12
Thomas Alonzo Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.1.5]
b. 18 Nov 1837 d. 2 Aug 1923 [
=>
]
12
John Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.1.6]
b. 9 Apr 1841 d. 21 Sep 1879
12
Olive Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.1.7]
b. 31 Jul 1843 d. Feb 1878
12
Dennis S Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.1.8]
b. 1 Nov 1852 d. 4 Dec 1865
11
Edwin Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.2]
b. 9 Nov 1806 d. 1894
+
Sophie Richards
11
Mary N Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.3]
b. 18 Jan 1809 d. 2 Apr 1900
Thomas Adams
c. 25 Aug 1806 d. 29 Apr 1875
12
Sophronia Adams
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.3.1]
b. 1836 [
=>
]
12
Edwin L Adams
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.3.2]
b. 1840
12
Melissa L Adams
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.3.3]
b. 1842 [
=>
]
12
Silvia J Adams
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.3.4]
b. 1845 [
=>
]
12
Melvina Adams
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.3.5]
b. 19 Jul 1849 d. 30 Apr 1912 [
=>
]
12
Melvin Adams
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.3.6]
b. 1852 [
=>
]
11
Louisa Noves
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.4]
b. 14 Mar 1811 d. 1876
William Deane
b. 26 Mar 1801
12
Mary Gibbs Deane
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.4.1]
b. 15 Aug 1830 [
=>
]
12
Cyrus Deane
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.4.2]
b. 9 Mar 1834 d. 17 Dec 1908 [
=>
]
12
William Penn Deane
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.4.3]
b. 24 Jul 1842 [
=>
]
12
Louisa Matilda Deane
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.4.4]
b. 4 Jul 1846 d. Aft 1873 [
=>
]
12
Alma Llewella Deane
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.4.5]
b. 7 Feb 1852
11
Delia Adams Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.5]
b. 10 Sep 1813
Joseph Avery
b. 1810
12
Adelia E Avery
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.5.1]
b. 12 May 1834
11
Rachel Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.6]
b. Abt 1817 d. 1838
11
Isaac C Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.7]
b. 27 Oct 1819 d. 12 Aug 1891
11
Nancy J Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.8]
b. 15 Jan 1823
11
Sophronia G Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.9]
b. 15 Jan 1824 d. 1871
Charles M Lufkin
b. 15 Jun 1824 d. 31 Aug 1906
12
Ellen Lufkin
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.9.1]
b. Abt 1850
12
Horace Greeley Lufkin
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.9.2]
b. Abt 1853
12
Charles Forrest Lufkin
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.9.3]
b. Aug 1857 [
=>
]
12
Adela "Adda" Lufkin
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.9.4]
b. Abt 1858 d. Abt 1882
12
Lucien S Lufkin
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.9.5]
b. Abt 1861 d. 1863
12
Fannie E Lufkin
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.9.6]
b. Abt 1862 d. 1863
11
Sarah N Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.10]
b. 15 Jan 1826 d. 1905
11
Francis Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.11]
b. 27 Oct 1828 d. 1828
11
Franklin Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.12]
b. 14 May 1829 d. 8 Nov 1896
11
Abigail M Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.13]
b. 1 Jun 1831
11
Charles Morse Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.14]
b. 1 Jun 1831 d. 6 Mar 1921
Helen Elizabeth Greenough
b. 17 Jan 1838 d. 5 Jun 1890
12
Harold Verne Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.14.1]
b. 1859 d. 1909 [
=>
]
12
Franklin Florence Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.14.2]
b. 23 Apr 1861 d. 1935 [
=>
]
12
Charles Warren Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.14.3]
b. 22 Dec 1863 d. 25 Apr 1947 [
=>
]
12
Annie R Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.14.4]
b. Nov 1868 d. 12 Apr 1870
12
Lena Estelle Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.14.5]
b. 1872 d. 8 Mar 1875
12
Clifford Greenough Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.14.6]
b. 18 Oct 1875 d. 5 Oct 1883
11
Flavilla P Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.15]
b. 8 Aug 1833 d. 1901
11
Philander E Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.16]
b. 3 Nov 1835
Elvira M Small
b. 1840
12
John R Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.16.1]
b. 8 Jan 1867 d. 26 Jan 1892
12
Alice L Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.16.2]
b. 7 Mar 1869
12
Florence E Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.16.3]
b. 14 Dec 1870
Lucinda J Huse
b. 1864
12
Reno P Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.16.4]
b. 3 Nov 1890
11
Julia A Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.6.17]
b. 8 Feb 1839 d. 1928
+
William W Jones
b. 1829 d. 1909
10
Samuel Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.7]
b. Oct 1784 d. 4 Jan 1864
Elisabeth Morill
b. 1785
11
Samuel Bradley Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.7.1]
b. 9 Apr 1817 d. 1900
Georgiana Beaumont
b. 1820
12
Teresa I Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.7.1.1]
b. 9 Aug 1851
12
Eliza R Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.7.1.2]
b. 22 Jun 1857
12
Bradley M Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.7.1.3]
b. 26 Dec 1864
12
James B Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.7.1.4]
b. 1 Nov 1870
11
Maria Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.7.2]
b. 30 Nov 1819 d. 1850
11
William A Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.7.3]
b. 17 Oct 1820
Abagail Rodgers
12
Emily L Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.7.3.1]
b. 15 Dec 1838
12
Edward E Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.7.3.2]
b. 14 May 1840
Mary Reddington Howe
b. 3 Dec 1824
12
Frances Eliza Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.7.3.3]
b. 7 Apr 1846
12
William Henry Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.7.3.4]
b. 3 Jul 1848
12
Sarah M Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.7.3.5]
b. 7 Oct 1849
12
Isabel A Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.7.3.6]
b. 18 Mar 1853
12
Emma G Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.7.3.7]
b. 5 Nov 1855 [
=>
]
11
Elisabeth Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.7.4]
b. 8 Oct 1823
11
Emaline Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.7.5]
b. 5 Jul 1827
11
George L Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.7.6]
b. 5 Apr 1839
Abbie Ordway
b. Abt 1842
12
George William Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.7.6.1]
b. 3 May 1864 d. 7 Jan 1918
12
George WM Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.7.6.2]
b. 3 May 1867
10
David Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.8]
b. 1784 d. 5 Jan 1854
Ruth Fiske
b. 1788
11
Charles L Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.8.1]
b. 1818
Delilah Gutterson
b. 1820
12
Grace Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.8.1.1]
b. 1845
10
Sarah Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.3.9]
b. Abt 1787
+
Thomas Cass
b. 1785
9
Daniel Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4]
b. 24 Nov 1748 d. 13 Jan 1822
Abigail Eames
b. 23 Apr 1758 d. 13 Jan 1824
10
Betsy Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.1]
b. 9 Jan 1778 d. 17 Jul 1843
Moses W Fife
b. 1783 d. 1859
11
Mary Magdalene Fife
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.1.1]
b. 18 Jun 1809 d. 1839
Ira Ames
b. 1803 d. 1865
12
Louisa Ames
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.1.1.1]
b. 1832
12
Betsey Ames
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.1.1.2]
b. 1834
12
Noyes Ames
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.1.1.3]
b. 1838
11
Peter Fife
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.1.2]
b. 15 Jan 1811 d. 13 Mar 1876
+
Louisa R Gordon
b. 3 Apr 1829 d. 9 Apr 1908
11
Betsey Fife
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.1.3]
b. 6 Feb 1812 d. 17 Feb 1884
John Chandler
b. 11 Mar 1807 d. 12 Nov 1892
12
Sophrona W Chandler
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.1.3.1]
b. 10 Feb 1837
12
William Perry Chandler
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.1.3.2]
b. 20 May 1839
12
Jay Chandler
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.1.3.3]
b. 4 Nov 1841
12
Emma Chandler
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.1.3.4]
b. 5 Dec 1843 [
=>
]
12
Wilson Chandler
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.1.3.5]
b. 13 Mar 1846
12
Ellen O Chandler
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.1.3.6]
b. 23 Dec 1851
11
Noyes Fife
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.1.4]
b. 13 Aug 1813 d. 1834
11
William Fife
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.1.5]
b. 7 Apr 1816 d. 17 Feb 1891
Ophelia Gordon
b. 14 Jul 1820 d. 15 Jun 1877
12
Elmore Fife
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.1.5.1]
b. 2 Oct 1842 d. 3 Apr 1917
12
Nelson Fife
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.1.5.2]
b. 13 Dec 1844
12
Orilla Fife
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.1.5.3]
b. Abt 1856 d. 5 Nov 1945
+
Mary D Wiley
b. 9 Oct 1818 d. 16 Sep 1901
11
Moses Fife
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.1.6]
b. 8 Feb 1818 d. 25 Aug 1890
Eliza Wyman
b. 15 Feb 1818 d. 18 May 1908
12
Micajah N Fife
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.1.6.1]
b. 16 Oct 1840 d. 20 Jul 1925
12
Mary Frances Fife
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.1.6.2]
b. 1844 d. 1931
12
Seth Wyman Fife
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.1.6.3]
b. 10 Dec 1846 d. 15 Jan 1915
12
Sarah Noyes Fife
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.1.6.4]
b. 17 Nov 1854 d. 28 Mar 1922
11
Daniel Fife
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.1.7]
b. 21 Sep 1819 d. 29 Jul 1908
Electra Ann Lowe
b. Abt 1826 d. 20 May 1877
12
Ellen A Fife
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.1.7.1]
b. 3 Dec 1848 d. Abt 1872/1880
12
Edwin Augustus Fife
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.1.7.2]
b. 13 Feb 1850 d. 29 Dec 1925 [
=>
]
12
Daniel L Fife
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.1.7.3]
b. 28 Aug 1851 d. 2 Jan 1922
12
Gertrude A Fife
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.1.7.4]
b. 13 Jul 1854 d. 24 Oct 1916 [
=>
]
12
Ella E Fife
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.1.7.5]
b. 25 Jul 1856 d. 15 Sep 1930
12
Edgar P Fife
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.1.7.6]
b. 7 Oct 1858 d. 24 Mar 1933
12
Wilson L Fife
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.1.7.7]
b. 17 Sep 1861 d. 4 Mar 1895 [
=>
]
12
Elmer Fife
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.1.7.8]
b. 28 Jun 1865 d. 1870
11
Mary Fife
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.1.8]
b. 4 Apr 1823
10
Daniel Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.2]
b. 10 Jun 1780
Nancy Davis
b. 14 Jun 1789
11
Daniel Davis Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.2.1]
b. 7 May 1822 d. 29 Dec 1893
Mrs Noyes
b. 1825
12
Edward Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.2.1.1]
b. 1848
11
Prudence Davis Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.2.2]
b. 20 Nov 1826 d. 17 Oct 1902
Paul Rollins Pickering
b. 8 Nov 1828 d. 18 Jun 1912
12
Walter Rollins Pickering
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.2.2.1]
b. 10 Jan 1857
12
Susan Gertrude Pickering
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.2.2.2]
b. 4 Mar 1859 d. 23 Dec 1925 [
=>
]
12
Alice Louise Pickering
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.2.2.3]
b. 27 Oct 1860 [
=>
]
11
Philip Henry Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.2.3]
b. 9 Aug 1828
Lydia H Thompson
b. 1830
12
Florence A Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.2.3.1]
b. 10 Oct 1858
12
Edwin H Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.2.3.2]
b. 1860
10
Abigail Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.3]
b. 15 Jan 1782 d. 30 Sep 1868
Benjamin Currier
d. 9 Dec 1864
11
Lydia Atkinson Currier
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.3.1]
b. 18 Jun 1807
11
Benjamin Currier
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.3.2]
b. 2 Jul 1821 d. 30 Jun 1865
+
Betsey D Foster
b. Abt 1823
10
Peter Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.4]
b. 29 May 1784 d. 26 Dec 1828
Eunice Meserve
b. Abt 1794
11
Abigail Eames Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.4.1]
b. 25 Mar 1816
11
Eliphalet Swett Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.4.2]
b. 30 Jun 1818
Laura K Hill
b. 27 Jul 1824 d. 1886
12
George H Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.4.2.1]
b. 13 Aug 1844
12
Elipha S Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.4.2.2]
b. 7 Oct 1847
12
Edwin B Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.4.2.3]
b. Aug 1849
12
Laura J Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.4.2.4]
b. Abt 1851
12
Frank L Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.4.2.5]
b. Abt 1853
12
Ernest C Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.4.2.6]
b. Abt 1855
11
Martha Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.4.3]
b. 15 Sep 1820 d. 21 Feb 1821
11
Peter W Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.4.4]
b. 18 Apr 1822
11
Martha Jane Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.4.5]
b. 3 Mar 1824
11
Thomas Jefferson Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.4.6]
b. 9 May 1827
10
Rebecca Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.5]
b. 10 Mar 1786 d. 30 Sep 1868
+
Samuel Bickford
b. 13 May 1779 d. 8 May 1863
10
Joseph Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.6]
b. 24 Mar 1788 d. 14 Jan 1850
Mehitabel Chase
b. 1792
11
George Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.6.1]
b. 30 Dec 1813
Mary E Sawyer
b. Abt 1820
12
Mary Francena Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.6.1.1]
b. 5 Jul 1844 d. 1919 [
=>
]
12
George D Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.6.1.2]
b. 16 Aug 1847
12
William H Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.6.1.3]
b. 29 Apr 1854
11
Rebecca Chase Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.6.2]
b. 12 Mar 1816 d. 18 Dec 1905
Reuel L Cram
b. 8 May 1813 d. 8 Nov 1894
12
Alonzo Cram
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.6.2.1]
b. 24 Dec 1836 d. 4 Feb 1837
12
Ellen Jane Cram
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.6.2.2]
b. 8 Nov 1837 [
=>
]
12
Charles Noyes Cram
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.6.2.3]
b. 15 Dec 1845 d. 9 Sep 1847
11
Charles Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.6.3]
b. 5 Dec 1817
Hannah Chase
b. 1820
12
Charles M Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.6.3.1]
b. 15 May 1850
12
James H Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.6.3.2]
b. 5 Aug 1855 [
=>
]
11
Daniel Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.6.4]
b. 24 Nov 1821
11
Joseph Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.6.5]
b. 10 Feb 1824
Sarah Leavitt
b. 1825
12
Joseph I Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.6.5.1]
b. 1850
11
Jacob Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.6.6]
b. 15 Oct 1825 d. 21 Mar 1897
Mary Dow
b. 14 Aug 1828
12
Mittie Chase Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.6.6.1]
b. 22 Sep 1853
11
Mary Elizabeth Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.6.7]
b. 4 Nov 1827 d. 27 Nov 1847
11
Henry Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.6.8]
b. 22 Jun 1833 d. 19 Jul 1854
11
Abigail A Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.6.9]
b. 25 Aug 1837
Thomas W Sanborn
b. Jan 1835
12
Josiah Butler Sanborn
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.6.9.1]
b. 1860 d. 1861
12
Thomas Edwin Sanborn
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.6.9.2]
b. Oct 1862
10
Jacob Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.7]
b. 1 Nov 1789 d. 21 Nov 1881
Ann Maria Ede
b. 17 Feb 1825 d. 20 Feb 1913
11
Eliza Ann Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.7.1]
b. 6 Nov 1842
George Green
b. 7 Jan 1835
12
Elma C Green
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.7.1.1]
b. Abt 1866
12
Clara B Green
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.7.1.2]
b. Abt 1869
12
Clayton Lafayette Green
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.7.1.3]
b. 13 Jun 1872
11
George Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.7.2]
b. 15 Dec 1844 d. 12 Dec 1920
Helen Elizabeth Bunker
b. 26 Sep 1852 d. 30 Apr 1925
12
George Myron Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.7.2.1]
b. 26 Aug 1884 d. 23 Nov 1918 [
=>
]
12
Clyde Wilbur Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.7.2.2]
b. 23 May 1886 d. 9 Feb 1965
12
Myrtle Maria Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.7.2.3]
b. 1 Jul 1888 d. 2 Dec 1958
12
Iva Cecelia Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.7.2.4]
b. 31 Mar 1890 d. 6 Jun 1956 [
=>
]
12
Inez Helen Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.7.2.5]
b. 21 Aug 1891 d. Jul 1983
12
Raymond Jacob Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.7.2.6]
b. 6 Feb 1893 d. 9 Mar 1935
11
Abigail Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.7.3]
b. 1847
11
Sophia Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.7.4]
b. 1851 d. 1 Jan 1934
11
Emma Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.7.5]
b. 1853
10
Sally Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.8]
b. 2 Nov 1791 d. 23 Aug 1860
Jonas Wyman
b. 15 Jan 1791 d. 22 Jun 1853
11
Eliza Wyman
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.8.1]
b. 15 Feb 1818 d. 18 May 1908
Moses Fife
b. 8 Feb 1818 d. 25 Aug 1890
12
Micajah N Fife
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.8.1.1]
b. 16 Oct 1840 d. 20 Jul 1925
12
Mary Frances Fife
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.8.1.2]
b. 1844 d. 1931
12
Seth Wyman Fife
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.8.1.3]
b. 10 Dec 1846 d. 15 Jan 1915
12
Sarah Noyes Fife
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.8.1.4]
b. 17 Nov 1854 d. 28 Mar 1922
11
Abigail Wyman
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.8.2]
b. 26 Jul 1821 d. 9 Nov 1909
Daniel Chandler
b. 22 Sep 1821 d. 29 Dec 1894
12
David Hardy Chandler
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.8.2.1]
b. 29 Feb 1848 d. 14 Oct 1906
12
Celissa Chandler
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.8.2.2]
b. 7 Oct 1851 d. 26 Sep 1853
12
Hazen Chandler
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.8.2.3]
b. 5 Feb 1855 d. 2 Aug 1923
12
Marshall Chandler
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.8.2.4]
b. 21 May 1858 d. 14 Mar 1862
12
Nellie Chandler
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.8.2.5]
b. 26 May 1864 d. 1925 [
=>
]
11
Seth Wyman
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.8.3]
b. 31 Aug 1823 d. 22 Sep 1883
Susan Hardwick Chandler
b. 26 Jan 1831 d. 10 Sep 1862
12
Joseph Leavitt Wyman
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.8.3.1]
b. 10 Oct 1850 d. 3 Nov 1877
12
Nancy Greely Wyman
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.8.3.2]
b. 16 Jun 1852 d. 24 Jul 1891 [
=>
]
12
Nellie F Wyman
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.8.3.3]
b. 17 Mar 1856 [
=>
]
12
Fannie Noyes Wyman
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.8.3.4]
b. 24 Sep 1859 d. 22 Mar 1939 [
=>
]
12
Susan Chandler Wyman
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.8.3.5]
b. 27 Jul 1862 d. 10 Mar 1943 [
=>
]
+
Clara H Rollins
b. 1845 d. Aft 1884
11
Jonas Wyman
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.8.4]
b. 8 Nov 1827 d. 24 Oct 1863
11
Susan Wyman
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.8.5]
b. 1830
10
Fanny Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.9]
b. 14 Feb 1794 d. 3 May 1856
10
Nancy Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.10]
b. 6 Jul 1796 d. 15 Mar 1826
Paine Davis Badger
b. 31 Jul 1796 d. 9 May 1863
11
Eliphlet Noyes Badger
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.10.1]
b. 9 May 1820 d. 18 Feb 1889
Sarah Frances Pettingill
b. 11 Dec 1822 d. 16 Jan 1895
12
Sarah Frances Badger
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.10.1.1]
b. 17 Sep 1843 [
=>
]
12
John Pettingell Badger
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.10.1.2]
b. 6 Nov 1845 d. 30 Dec 1889 [
=>
]
12
George Henry Badger
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.10.1.3]
b. 24 Jan 1848 d. 7 Nov 1870
12
Arthur E Badger
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.10.1.4]
b. 16 Apr 1850 d. 6 Apr 1891
12
Mary Eliza Badger
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.10.1.5]
b. 26 Mar 1853 d. 16 Nov 1873
12
Edward Noyes Badger
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.10.1.6]
b. 28 Apr 1858 d. 19 Oct 1906 [
=>
]
11
George W Badger
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.10.2]
b. 1822 d. 20 Jun 1856
Mary Ann Tripp
12
Georgianna Badger
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.10.2.1]
b. 8 May 1845
12
Sarah Frances Badger
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.10.2.2]
b. 30 Sep 1848
11
Elizabeth Badger
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.10.3]
b. 1824 d. 1874
10
Micajah Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.11]
b. 7 Aug 1798
Elizabeth Chamberlain
b. Abt 1801
11
Micajah Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.11.1]
b. Oct 1831 d. 4 Feb 1895
Mrs. Noyes
b. 1835
12
Harry B Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.11.1.1]
b. 28 Dec 1864
12
William A Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.11.1.2]
b. 18 Oct 1872
11
Lizzie N Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.11.2]
b. Abt 1833
11
Jennie Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.11.3]
b. Abt 1835
11
Son Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.11.4]
b. 1837
10
Eliphalet Swett Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.4.12]
b. 7 Mar 1802 d. 17 Apr 1820
9
Enoch Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.5]
b. 28 Mar 1750 d. 20 May 1842
Eunice Kinsman
b. Abt 1749
10
Betsy Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.1]
b. 13 Dec 1771 d. 1848
+
Jesse Frye
10
Elizabeth Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.2]
b. 13 Dec 1771
10
Eunice Kinsman Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.3]
b. 21 Apr 1774 d. 5 Aug 1853
Amos Bartlett
b. Abt 1770 d. 20 Aug 1828
11
Stephen Noyes Bartlett
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.3.1]
b. 1 Dec 1802 d. 15 Nov 1879
Theodisa Child
b. 18 Sep 1802 d. 31 Jan 1882
12
Emery Sargent Bartlett
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.3.1.1]
b. 18 Sep 1828 d. 27 Oct 1864 [
=>
]
12
Eliza Ann Bartlett
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.3.1.2]
b. 18 Sep 1828 d. 27 Oct 1864
12
Moses Willard Bartlett
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.3.1.3]
b. 26 Feb 1834 d. 30 Nov 1912 [
=>
]
12
Stanley Moulton Bartlett
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.3.1.4]
b. 4 Dec 1836 d. 24 Nov 1908
12
Philomela Minerva Bartlett
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.3.1.5]
b. 23 Jul 1839 d. 25 Aug 1903
11
Sukey Bartlett
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.3.2]
b. 28 Apr 1800
11
Joseph K Bartlett
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.3.3]
b. 7 May 1805 d. 1832
11
Philomela Bartlett
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.3.4]
b. 22 May 1808
+
John Gardner
11
Julia Ann Bartlett
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.3.5]
b. 10 Nov 1810 d. 7 Apr 1894
11
Enoch Noyes Bartlett
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.3.6]
b. 4 Jul 1813 d. 14 Aug 1897
Emily Smith
b. 27 May 1814
12
Julia E Bartlett
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.3.6.1]
b. 1843 d. 1844
12
George W Bartlett
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.3.6.2]
b. 3 Sep 1845
12
Joseph E Bartlett
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.3.6.3]
b. 5 Oct 1848
12
Horace M Bartlett
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.3.6.4]
b. 7 Apr 1859
11
Moses Emery Bartlett
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.3.7]
b. 30 Apr 1816 d. 21 Feb 1847
Catharine C Kirby
b. 8 Dec 1816 d. 6 Aug 1842
12
Henry Lindsley Barlett
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.3.7.1]
b. 20 Sep 1838 d. 14 Oct 1838
12
Maria Jackson Barlett
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.3.7.2]
b. 16 Jan 1841 d. 15 Oct 1903 [
=>
]
12
Julia Ann Barlett
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.3.7.3]
b. 15 Jul 1842 d. 17 Sep 1896
10
Isaac Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.4]
b. 3 Jan 1776 d. 3 Dec 1862
Rachel Worthley
b. Abt 1782 d. 25 Apr 1841
11
Bradley Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.4.1]
b. 20 Feb 1801 d. 14 May 1858
Martha Sullivan Bordwell
b. 21 Nov 1809 d. 1868
12
Isabella Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.4.1.1]
b. 30 Sep 1830 d. 22 Jul 1901
12
Sophia M Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.4.1.2]
b. 20 Sep 1832 [
=>
]
12
Thomas Jefferson Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.4.1.3]
b. 2 Dec 1834 [
=>
]
12
Edward Livingston Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.4.1.4]
b. 21 Sep 1836 d. 30 Oct 1933 [
=>
]
12
Martha Ann Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.4.1.5]
b. 30 Aug 1838
12
Luella S Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.4.1.6]
b. 15 May 1841 d. 1876
12
Baxter Buffman Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.4.1.7]
b. 22 Aug 1843 d. 22 Jul 1912 [
=>
]
12
Joseph B Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.4.1.8]
b. 9 Apr 1854
11
Ann Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.4.2]
b. 25 May 1806 d. 1 Sep 1849
David Rollins
b. 9 Jan 1790 d. 18 Mar 1874
12
Judith Louisa Rollins
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.4.2.1]
b. 5 Jul 1815 d. 30 Apr 1890 [
=>
]
12
Asenath Rawlins
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.4.2.2]
b. 16 Sep 1817
12
Emily Rawlins
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.4.2.3]
b. 5 Dec 1819 [
=>
]
12
Eliza A Rollins
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.4.2.4]
b. 13 Feb 1822 [
=>
]
12
Joseph L Rollins
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.4.2.5]
b. 23 Feb 1825
12
Mary J Rawlins
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.4.2.6]
b. 17 Jan 1828
12
Harriet Rawlins
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.4.2.7]
b. 28 Apr 1830
12
David H Rollins
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.4.2.8]
b. 22 Aug 1840
11
Mary Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.4.3]
b. 23 Oct 1808
11
Isaac Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.4.4]
b. 6 Jan 1811 d. 31 Dec 1876
Eliza Stephens
b. Abt 1811
12
Emily Kinsman Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.4.4.1]
b. 17 Feb 1834 d. 18 Aug 1916 [
=>
]
12
Ursula A Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.4.4.2]
b. 13 Mar 1840
12
Joseph S Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.4.4.3]
b. 1 Jul 1842 d. 28 May 1881
12
Samuel W D Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.4.4.4]
b. 7 Feb 1846 [
=>
]
12
Harriet C Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.4.4.5]
b. 2 Aug 1848
12
Isaac E Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.4.4.6]
b. 24 Sep 1852 d. 19 Feb 1864
12
Dewitt C Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.4.4.7]
b. 12 Nov 1854
12
Son Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.4.4.8]
b. 1856
12
Son Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.4.4.9]
b. 1858
11
Enoch Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.4.5]
b. 12 Mar 1814 d. 9 Jul 1852
Margaret Oliver
b. 1818 d. 4 Oct 1885
12
Enoch Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.4.5.1]
b. 27 Dec 1837 d. 27 Dec 1837
12
Mary Frances Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.4.5.2]
b. 1842
12
Isaac Enoch Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.4.5.3]
b. 1844
11
Samuel Newell Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.4.6]
b. 19 Jul 1818
Mary A Curtis
b. Abt 1826
12
Algernon F Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.4.6.1]
b. 12 Nov 1848 d. 9 Nov 1891 [
=>
]
12
Eda Mara Augusta Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.4.6.2]
b. 21 May 1850 d. 8 Sep 1918 [
=>
]
12
Gerza H Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.4.6.3]
b. 16 Feb 1852 d. 1899
11
Ursula Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.4.7]
b. 30 Aug 1821 d. 23 Dec 1866
Lorenzo Dow Livermore
b. 28 Nov 1819 d. 14 May 1906
12
Orell Bradley Livermore
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.4.7.1]
b. 9 Jun 1845 d. 29 Aug 1848
12
Aldrick Clarence Livermore
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.4.7.2]
b. 29 Oct 1848 d. 29 Jul 1862
12
Elgin Serino Livermore
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.4.7.3]
b. 17 May 1850
12
Adelphia Ursula Livermore
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.4.7.4]
b. 23 Oct 1853
12
Winslow Odell Livermore
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.4.7.5]
b. 17 May 1856 d. Aft 1902 [
=>
]
12
Benjamin Franklin Livermore
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.4.7.6]
b. 30 Jan 1860 d. Aft 1902 [
=>
]
12
Alfrenzo Livermore
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.4.7.7]
b. 10 Jun 1864 d. 24 Jun 1864
10
Enoch Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.5]
b. 15 Dec 1777 d. 1800
+
Abigail
b. 1779
10
Lydia Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.6]
b. 26 Nov 1779 d. 8 Aug 1818
Aaron Manning
b. 1 Apr 1775 d. 15 Jun 1827
11
James Manning
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.6.1]
b. 28 Nov 1800 d. 11 Jul 1811
11
Enoch Noyes Manning
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.6.2]
b. 13 Jul 1802 d. 1858
11
Stephen Noyes Manning
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.6.3]
b. 24 Oct 1804
+
Lucy Prescott
b. 10 Jul 1810 d. 21 Apr 1867
11
Aaron Manning
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.6.4]
b. 17 Aug 1806 d. 18 Mar 1845
+
Harriet Elizabeth McCarty
b. 16 Feb 1812 d. 19 Oct 1883
11
Jesse King Manning
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.6.5]
b. 1 Feb 1809
+
Jane Ann Marshall
b. 15 Dec 1815 d. 10 Mar 1853
11
Son Manning
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.6.6]
b. 1811 d. 1811
11
James Maddison Manning
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.6.7]
b. 4 Mar 1812 d. 1872
+
Mary Ann Wool
11
Eunice Kinsman Manning
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.6.8]
b. 9 Jan 1814 d. 5 Aug 1892
Leander Danforth
b. 30 Jan 1807 d. 8 Jul 1882
12
Eudora Elizabeth Danforth
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.6.8.1]
b. 26 Jun 1841
12
Florence Arrabel Danforth
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.6.8.2]
b. 10 Nov 1843 [
=>
]
12
Rosalie Aurelia Danforth
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.6.8.3]
b. 6 Oct 1847 d. 23 Oct 1880
11
Lydia Noyes Manning
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.6.9]
b. 12 May 1816 d. 8 Sep 1837
11
William Manning
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.6.10]
b. 12 Jun 1818 d. 23 Oct 1891
Agnes Magdelen Witbeck
b. 19 Mar 1821 d. 6 Jun 1896
12
Daniel Francis Manning
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.6.10.1]
b. 9 Sep 1839
12
Egbert Addison Manning
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.6.10.2]
b. 3 Mar 1843 d. 1900 [
=>
]
12
James Frederick Manning
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.6.10.3]
b. 5 Apr 1847
12
Agnes Lydia Manning
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.6.10.4]
b. 11 Sep 1849 d. 5 Apr 1927 [
=>
]
10
Susan Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.7]
b. 3 Dec 1781
Moses Sargent
b. 1782 d. 11 Jun 1820
11
Angeline Sargent
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.7.1]
b. 2 Nov 1805
+
Elijah Hathaway
b. 19 Jan 1794 d. 24 Apr 1880
11
Susan M Sargent
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.7.2]
b. 12 Apr 1811 d. 1888
Calvin Sabin Grow
b. 6 Mar 1805 d. 13 May 1896
12
Lucius A Grow
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.7.2.1]
b. 7 Sep 1832
12
Perlina L Grow
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.7.2.2]
b. 16 Mar 1834 d. 3 Jan 1909
12
Annie E Grow
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.7.2.3]
b. 11 Aug 1836
12
Helen A Grow
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.7.2.4]
b. 14 Aug 1840 d. 14 Nov 1861
12
Florence A Grow
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.7.2.5]
b. 1 May 1844 [
=>
]
12
James M Grow
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.7.2.6]
b. 1 May 1844
10
Stephen Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.8]
b. 5 Jul 1783 d. 1866
Sarah Abbott
b. 3 Oct 1788
11
Enoch Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.8.1]
b. 16 Jul 1806 d. 18 May 1811
11
Susan Parker Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.8.2]
b. 12 Nov 1808 d. 31 Jan 1846
Joshua D Allen
b. 1800
12
Stephen N Allen
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.8.2.1]
b. 28 May 1830
12
Joshua B Allen
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.8.2.2]
b. 9 Mar 1832
12
Sarah N Allen
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.8.2.3]
b. 19 Nov 1834
12
Joseph S Allen
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.8.2.4]
b. 15 Jul 1840
11
Benjamin A Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.8.3]
b. 16 Mar 1811 d. 13 Feb 1865
Lucy A Thompson
b. Abt 1813 d. Aft 1839
12
Lucia A Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.8.3.1]
b. 22 Nov 1835
12
Lavina Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.8.3.2]
b. 10 Sep 1839
11
Stephen Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.8.4]
b. 26 May 1817 d. 22 Mar 1822
10
Dorcas Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.9]
b. 22 Mar 1786 d. 27 Feb 1877
Benjamin Abbott
b. 23 Sep 1786 d. 22 Jun 1853
11
Ephraim Abbott
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.9.1]
b. 25 Oct 1808 d. Apr 1813
11
Susannah Manning Abbott
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.9.2]
b. 13 Dec 1810 d. Mar 1898
Jesse Frye
b. 15 Feb 1813 d. 1864
12
Benjamin Abbott Frye
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.9.2.1]
b. 18 Aug 1843 [
=>
]
12
Eunice Laura Frye
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.9.2.2]
b. 9 Jun 1847
11
Peter Green Abbott
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.9.3]
b. 8 May 1815 d. 7 Nov 1829
11
Enoch Noyes Abbott
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.9.4]
b. 16 Dec 1817 d. 18 Feb 1855
Maria H Wood
b. Abt 1821 d. 6 Jun 1866
12
Mary B Abbott
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.9.4.1]
b. 15 Jun 1846 d. Abt 1870
12
Susan Maria Abbott
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.9.4.2]
b. Abt 1848
11
Asa McFarland Abbott
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.9.5]
b. 16 Nov 1820 d. 8 Apr 1889
Sarah Sperry
b. 18 Feb 1822 d. 12 May 1900
12
Charles Enoch Abbott
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.9.5.1]
b. 22 Dec 1847 d. 10 Jan 1928 [
=>
]
12
John Morton Abbott
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.9.5.2]
b. 25 Mar 1850 d. 16 May 1936 [
=>
]
12
Ruth Abbott
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.9.5.3]
b. 23 Jun 1852 d. 12 May 1855
12
Theodore Sperry Abbott
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.9.5.4]
b. 23 Sep 1855 d. 16 Aug 1934
12
Edward Lorenzo Abbott
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.9.5.5]
b. 15 Feb 1859 d. 30 Sep 1938
12
William Lamont Abbott
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.9.5.6]
b. 14 Feb 1861 d. 20 Feb 1951 [
=>
]
12
Alfred Noyes Abbott
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.9.5.7]
b. 2 Nov 1862 d. 14 Sep 1929 [
=>
]
11
Laura Dorcas Abbott
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.9.6]
b. 31 Mar 1824 d. 14 Feb 1853
+
Alanson Paul Morton
b. Abt 1820 d. Mar 1872
11
Ruth Morrill Abbott
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.9.7]
b. 15 Feb 1828 d. 30 Sep 1832
10
Aaron Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.10]
b. 4 Apr 1787 d. 17 Oct 1787
10
Fanny Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.11]
b. 11 Sep 1788 d. 1881
Stephen Sargent
b. 4 Feb 1785 d. 25 Dec 1825
11
Stephen Emery Sargent
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.11.1]
b. 2 Sep 1809 d. 24 Jan 1893
Anna A Allbee
b. 1815 d. 1853
12
Ada Sargent
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.11.1.1]
b. 1848
Elizabeth Cook
b. 2 Oct 1828
12
Ada Ellen Sargent
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.11.1.2]
b. 11 Apr 1860
12
Emma Agnes Sargent
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.11.1.3]
b. 20 Nov 1863 d. 20 Dec 1864
11
Fanny Maria Sargent
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.11.2]
b. 4 Aug 1811 d. 25 Sep 1900
Benjamin Moore
b. 30 Dec 1800 d. 30 Jun 1853
12
Perlea Maria Moore
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.11.2.1]
b. 30 Jun 1845 d. 8 Aug 1905 [
=>
]
11
Susan Sargent
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.11.3]
b. 18 Sep 1813 d. 1840
11
Ann K Sargent
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.11.4]
b. 30 Nov 1815
+
Peter Warren
11
Betsey Sargent
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.11.5]
b. 22 Nov 1817
George W Sawyer
b. 1813
12
George W Sargent
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.11.5.1]
b. 12 Feb 1842
12
Stephen A Sargent
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.11.5.2]
b. 13 Nov 1843 [
=>
]
11
Roger Moses Sargent
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.11.6]
b. 7 Sep 1824
Elizabeth Goodrich Spaulding
b. 27 Mar 1824 d. Abt 1895
12
Mary Ann Sargent
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.11.6.1]
b. 1 Apr 1851 d. 25 Sep 1851
12
Roger Moses Sargent
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.11.6.2]
b. 7 May 1852 d. 16 May 1852
12
Howard Merton Sargent
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.11.6.3]
b. 24 Jul 1853 [
=>
]
12
Clarence Spaulding Sargent
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.11.6.4]
b. 29 Jul 1855 d. 21 Sep 1921 [
=>
]
12
Edwin Charlton Sargent
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.11.6.5]
b. 10 Jun 1857 d. 9 Jan 1873
12
Fanny Elizabeth Sargent
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.11.6.6]
b. 17 May 1859 d. 22 Jan 1864
12
Roger Moses Sargent
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.11.6.7]
b. 30 Oct 1862 d. 1 Jan 1863
10
Frances Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.5.12]
b. 11 Sep 1788
9
Aaron Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6]
b. 28 Nov 1752 d. 11 Mar 1827
Betsy Ladd
b. 3 Sep 1756 d. 4 Jul 1836
10
True Worthy Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.1]
b. 19 Jul 1774
Polly King
b. 30 Oct 1775
11
James King Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.1.1]
b. 12 Nov 1798 d. 6 Jan 1870
Eunice Brown
b. Abt 1800 d. 15 Apr 1888
12
Dana M Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.1.1.1]
b. 1823 [
=>
]
12
Mary J Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.1.1.2]
b. Abt 1827 d. 28 Feb 1893 [
=>
]
11
Delia Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.1.2]
b. 18 Aug 1800 d. 30 Oct 1822
Ormand Hunt
b. 4 Jan 1794 d. 10 Mar 1861
12
Simeon Hunt
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.1.2.1]
b. 7 Jul 1821 d. 4 Dec 1889
12
Herman Hunt
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.1.2.2]
b. 14 Oct 1824 d. 16 Dec 1862 [
=>
]
12
Mary E Hunt
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.1.2.3]
b. Abt 1828 d. 4 Mar 1832
12
Amanda Hunt
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.1.2.4]
b. 12 Dec 1832 d. 11 Apr 1910
11
Worth True Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.1.3]
b. 9 Jul 1805
11
Hiram King Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.1.4]
b. 9 Jun 1810 d. 1877
Susannah G Bourn
b. 28 Mar 1820
12
William Gilman Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.1.4.1]
b. 17 Jun 1842 d. 8 Feb 1927
12
Levi D Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.1.4.2]
b. 1844
12
Lucy Anna Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.1.4.3]
b. 15 May 1846 [
=>
]
12
Lansford Whiting Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.1.4.4]
b. 21 Apr 1847 d. 14 Oct 1919 [
=>
]
12
Amanda B Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.1.4.5]
b. 1849
12
Lewis A Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.1.4.6]
b. 1854
12
Charles Eugene Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.1.4.7]
b. 20 Apr 1854 [
=>
]
12
Wesley F Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.1.4.8]
b. 1856
12
Ruby Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.1.4.9]
b. 1859
12
Etta "Mary" Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.1.4.10]
b. 12 Jun 1866 d. 23 Jun 1909
11
Nathaniel King Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.1.5]
b. 9 Oct 1811 d. 30 Mar 1891
Susan Sargent
b. 7 Aug 1813 d. 8 Nov 1871
12
Delia A Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.1.5.1]
b. 12 Nov 1834 d. 13 Dec 1919 [
=>
]
12
Emily K Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.1.5.2]
b. 9 Apr 1837 d. 5 Oct 1921 [
=>
]
12
Abner K Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.1.5.3]
b. 23 Jul 1841 d. 22 May 1920 [
=>
]
12
Sarah Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.1.5.4]
b. Jun 1844 d. 27 Aug 1926 [
=>
]
12
Marietta "Etta" Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.1.5.5]
b. 1848 d. 7 Apr 1878 [
=>
]
12
Charles Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.1.5.6]
b. May 1850 d. 2 Jan 1929
12
Benjamin Franklin Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.1.5.7]
b. 21 Jan 1852 d. 12 Jul 1933 [
=>
]
12
Frances Adelade Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.1.5.8]
b. 6 Aug 1854 d. 8 Apr 1925 [
=>
]
12
Ezra William Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.1.5.9]
b. Oct 1857 d. 24 Aug 1931
Sarah Jane Aldrich
b. 22 Jan 1840 d. 10 Mar 1926
12
Bessie May Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.1.5.10]
b. 5 Nov 1872 d. 15 Aug 1918 [
=>
]
12
Jessie King Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.1.5.11]
b. 27 Jul 1874 d. 26 May 1957 [
=>
]
12
Bertha Edna Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.1.5.12]
b. 24 May 1876 d. 10 Apr 1928
12
Flora Adell Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.1.5.13]
b. 19 Jul 1880 d. 12 May 1919 [
=>
]
11
William K Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.1.6]
b. Abt 1815
10
Aaron Noyes, Jr
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.2]
b. 3 Apr 1776 d. 16 Feb 1813
Elizabeth "Betsy" King
b. 5 Jun 1777 d. 23 Oct 1833
11
Laura K Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.2.1]
b. 14 Jun 1799 d. 11 Dec 1844
Aaron Noyes
b. 30 Sep 1790 d. 21 Oct 1820
12
Aaron G Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.2.1.1]
b. Abt 1824
+
Joseph F Lamson
b. 1793 d. Oct 1869
11
Ira Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.2.2]
b. 25 Apr 1801 d. 19 Sep 1802
11
Herman Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.2.3]
b. 28 Apr 1803 d. 31 Dec 1876
Sarah W Powell
b. 22 May 1813 d. 27 Jul 1900
12
Mary E Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.2.3.1]
b. 6 Mar 1835 d. Apr 1907
12
Laura P Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.2.3.2]
b. 22 Jul 1837 d. Bef 1860
12
Philo G Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.2.3.3]
b. 4 Jul 1840 d. 4 Nov 1861
12
John Powell Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.2.3.4]
b. 15 Sep 1842 d. 14 May 1924 [
=>
]
12
Almon H Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.2.3.5]
b. 15 Dec 1844 d. 14 Mar 1925 [
=>
]
12
Roxana Saloma Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.2.3.6]
b. 1 Aug 1847 d. 1931 [
=>
]
12
Harriet C Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.2.3.7]
b. 10 Jul 1852 d. 19 May 1881
12
Abbie A Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.2.3.8]
b. 27 Aug 1855
11
Almon Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.2.4]
b. 9 Mar 1805 d. 10 Apr 1873
11
Mary Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.2.5]
b. 8 May 1807 d. 10 Jun 1834
10
Lydia Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3]
b. 22 Aug 1778 d. 5 Feb 1869
Nathaniel King
b. 4 May 1767 d. 18 Oct 1857
11
Deliverance "Dilly" King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.1]
b. 5 Jul 1795 d. 23 Apr 1873
James Goodwin
b. 1793
12
Lydia King Goodwin
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.1.1]
b. 17 Mar 1815 d. 11 Aug 1905 [
=>
]
12
Dilly Goodwin
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.1.2]
b. 7 Oct 1816 d. 25 Aug 1854 [
=>
]
12
Julia King Goodwin
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.1.3]
b. 17 Dec 1818 d. 30 Nov 1898 [
=>
]
12
James K Goodwin
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.1.4]
b. 26 Jun 1821 [
=>
]
11
Lydia King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.2]
b. 13 Mar 1797 d. 4 Dec 1893
Stephen Herrick
b. 19 Feb 1795 d. 19 Mar 1885
12
Eliza King Herrick
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.2.1]
b. 14 Oct 1820 d. 18 Mar 1897 [
=>
]
12
Nathaniel King Herrick
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.2.2]
b. 3 Nov 1822 d. 30 Jan 1891 [
=>
]
12
Emily Rosette Herrick
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.2.3]
b. 23 Nov 1825 d. 29 Apr 1848
12
Harriet Perlina Herrick
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.2.4]
b. 26 Feb 1829 d. 29 Mar 1868 [
=>
]
12
Laura Jane Herrick
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.2.5]
b. 11 Jun 1831 d. 1894 [
=>
]
12
Nancy Janetta Herrick
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.2.6]
b. 21 Mar 1834 d. Nov 1916 [
=>
]
12
Lydia Ann Herrick
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.2.7]
b. 3 Mar 1838 d. 12 Feb 1899
12
Alma Rosetta Herrick
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.2.8]
b. 24 Mar 1842 d. 7 Sep 1913 [
=>
]
11
Hanna Harvey King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.3]
b. 17 Feb 1799 d. 18 Jun 1838
Joseph F Lamson
b. 1793 d. Oct 1869
12
Susanna Lampson
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.3.1]
b. 14 Dec 1818
12
Nancy Lamson
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.3.2]
b. 1820 d. 1832
12
Joshua F Lamson
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.3.3]
b. 3 Oct 1822 d. 1 Mar 1886
12
Nathaniel King Lamson
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.3.4]
b. 1824 d. Abt 1898
12
Joseph Lampson
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.3.5]
b. 1 Feb 1828 d. 1910
12
Theodore Cook Lamson
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.3.6]
b. 18 Jul 1831 d. 3 Jan 1911
11
Hatty King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.4]
b. 8 Mar 1801 d. 22 Aug 1833
Howard Moulton
b. 5 Jan 1792 d. 6 Aug 1859
12
Nathaniel L Moulton
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.4.1]
b. Abt 1822
12
Eliza K Moulton
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.4.2]
b. Abt 1824 d. Aft 1860 [
=>
]
12
Nancy K Moulton
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.4.3]
b. Abt 1828 [
=>
]
11
Abigail King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.5]
b. 13 Aug 1803 d. 13 Oct 1858
William Putnam
b. 5 Oct 1799
12
Son Putnam
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.5.1]
b. Aug 1827 d. 29 Aug 1827
12
Abijah M Putnam
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.5.2]
b. Abt 1830 d. 20 Aug 1832
12
Nathaniel K Putnam
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.5.3]
b. 3 Jun 1832 [
=>
]
12
Lydia Ann Putnam
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.5.4]
b. 13 Aug 1834 [
=>
]
12
Emeline N Putnam
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.5.5]
b. 23 Jun 1836 [
=>
]
12
Sarah Jane Putnam
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.5.6]
b. Abt 1839 d. 29 May 1842
11
Eliza Harvey King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.6]
b. 9 Jun 1807 d. Oct 1900
John Hunt
b. 1 Aug 1802 d. 3 Oct 1887
12
Daughter Hunt
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.6.1]
b. 9 Feb 1829 d. 9 Feb 1829
12
Laurentio Gonsalvi Hunt
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.6.2]
b. 23 Oct 1830 d. 12 Jan 1919 [
=>
]
12
Sarah Aurora Hunt
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.6.3]
b. 22 Sep 1832 d. 8 Jan 1901 [
=>
]
12
Harty H Hunt
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.6.4]
b. 20 Oct 1834 d. 4 Nov 1894 [
=>
]
12
Nathaniel King Hunt
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.6.5]
b. 23 Jan 1837 d. 20 Dec 1924 [
=>
]
12
Lydia King Hunt
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.6.6]
b. 26 Jul 1840
12
Simeon Hunt
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.6.7]
b. 29 Jan 1843 d. 15 Apr 1859
12
Garretta Hunt
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.6.8]
b. 13 Mar 1845
12
Eliza A Hunt
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.6.9]
b. 12 Dec 1847 [
=>
]
12
John Hunt
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.6.10]
b. 9 Jun 1850 d. 1908 [
=>
]
11
Sally Hacket King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.7]
b. 11 Apr 1809 d. 28 Nov 1890
Moody Smith
b. 9 Sep 1801
12
Janet L Smith
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.7.1]
b. Abt 1833
12
Laura A Smith
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.7.2]
b. Abt 1835
11
Phillip King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.8]
b. 4 Jul 1811
11
Nancy Folsom King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.9]
b. 30 Oct 1813 d. 17 Jan 1906
Jeremiah Brown
b. Abt 1810 d. 14 Oct 1883
12
Son Brown
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.9.1]
b. 1836 d. 4 Nov 1836
12
Son Brown
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.9.2]
b. 1837 d. 27 Nov 1840
11
Daniel P King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.10]
b. Abt 1815
11
Harvey King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.11]
b. 22 Mar 1818
Jane Lyman
b. 7 Aug 1816 d. 11 Apr 1852
12
Jane Lyman King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.11.1]
b. 10 Aug 1845 d. 14 May 1921
12
Fanny Brunar King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.11.2]
b. 6 Sep 1849
11
Aaron Nathaniel King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.12]
b. 1 Jul 1820 d. 13 Sep 1901
Eliza B Nutter
b. 10 Mar 1823 d. 24 Jul 1876
12
Heber Aaron King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.12.1]
b. 14 Mar 1843 d. 2 Dec 1869
12
Millard Taylor King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.3.12.2]
b. 20 Aug 1848 d. 13 Dec 1916
10
Mehitable Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4]
b. 18 Jan 1780 d. 11 Jan 1852
George King
b. 15 Nov 1773 d. 2 Oct 1835
11
Abigail King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.1]
b. 10 Jun 1800 d. 25 Aug 1887
Moses Wilds
b. 8 Oct 1790 d. 1 Nov 1879
12
Mary Wilds
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.1.1]
b. 14 Feb 1818 d. 21 Apr 1895 [
=>
]
12
Lydia Wilds
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.1.2]
b. 4 Feb 1820 [
=>
]
12
Mehitable "Hittie" Wilds
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.1.3]
b. 17 Jun 1826 d. 1 Nov 1910 [
=>
]
12
Sally J Wilds
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.1.4]
b. Abt 1828 [
=>
]
12
Cynthia C Wilds
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.1.5]
b. 30 Aug 1831 d. 26 May 1930
11
Hiram King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.2]
b. 14 May 1802 d. 11 Jul 1862
Sally Colby
b. 6 May 1800 d. 19 Oct 1871
12
Joshua King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.2.1]
b. 3 Aug 1825
12
Caroline King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.2.2]
b. 18 Jun 1827 d. 23 Mar 1905 [
=>
]
12
Corodon N King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.2.3]
b. 6 Sep 1829 d. 1900
12
Calista King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.2.4]
b. 10 Apr 1833 [
=>
]
12
Rosalthie King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.2.5]
b. 1 Apr 1836 d. 17 May 1865 [
=>
]
12
Adelia King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.2.6]
b. 12 May 1839 d. 25 Dec 1915
12
Julia A King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.2.7]
b. 5 Apr 1843 d. 1 Aug 1930 [
=>
]
11
Sarah King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.3]
b. 19 Jan 1804 d. 13 Mar 1866
William Wilds
b. 16 Jan 1800 d. 16 Feb 1876
12
Diantha Wilds
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.3.1]
b. 2 Dec 1831 [
=>
]
12
Diana Wilds
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.3.2]
b. 2 Dec 1831 [
=>
]
12
Merrill F Wilds
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.3.3]
b. 23 Dec 1832 d. 27 Jul 1903 [
=>
]
12
Sarah King Wilds
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.3.4]
b. 2 May 1834 d. 29 Jan 1906 [
=>
]
12
Louisa Wilds
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.3.5]
b. 13 Dec 1838 d. 26 Dec 1893 [
=>
]
12
Almira Elizabeth Wilds
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.3.6]
b. 11 Sep 1840 d. 21 Feb 1906 [
=>
]
12
John K Wilds
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.3.7]
d. 5 Feb 1909 [
=>
]
11
Susan King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.4]
b. 2 Aug 1807 d. 17 Oct 1887
Hezekiah Felch Dickey
b. 28 Sep 1809 d. 12 Oct 1895
12
Cyrus F Dickey
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.4.1]
b. 24 Jun 1832 d. 28 Nov 1892 [
=>
]
12
Lucinda D Dickey
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.4.2]
b. 28 Jul 1837 d. 4 Sep 1898 [
=>
]
12
Alvina Dickey
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.4.3]
b. 6 Oct 1839 d. 2 Dec 1927 [
=>
]
11
Betsy N King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.5]
b. 12 Mar 1810 d. 9 Apr 1888
Robert F Goodwin
b. 8 Oct 1809 d. 4 Jun 1888
12
Isaac H Goodwin
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.5.1]
b. 3 Oct 1844 d. 17 Jun 1913 [
=>
]
12
George Francis Goodwin
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.5.2]
b. 12 Jan 1849 d. 19 Jan 1918 [
=>
]
11
Sophia King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.6]
b. 18 Jun 1812 d. 10 Dec 1815
11
Field King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.7]
b. 23 Mar 1814 d. 10 Dec 1815
11
George King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.8]
b. 16 Jan 1816 d. 1 Nov 1872
Diana Darling
b. 13 Oct 1811 d. 29 Apr 1845
12
Almira Myra King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.8.1]
b. 28 Mar 1837 d. 27 Sep 1900
12
Lucy A King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.8.2]
b. 24 Apr 1839 d. 1884
12
Charles Cyrus King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.8.3]
b. 13 Oct 1840 d. 30 Nov 1918 [
=>
]
12
Diana Elizabeth King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.8.4]
b. 31 Dec 1842 d. 10 Oct 1898 [
=>
]
12
Chester Dickey King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.8.5]
b. 2 Nov 1844 d. 13 Feb 1864
12
Son King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.8.6]
b. Abt 1846 d. 1846
Rebecca Burbank
b. 1 Feb 1817 d. 22 Aug 1898
12
Sophia King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.8.7]
b. 11 Mar 1846 d. 3 Jul 1904 [
=>
]
12
George King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.8.8]
b. 23 Sep 1849 d. 20 May 1851
12
Cortez General King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.8.9]
b. 12 Jun 1851 d. 23 Sep 1894 [
=>
]
12
Mary R King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.8.10]
b. 9 Feb 1853 d. 21 Dec 1921 [
=>
]
12
Major S King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.8.11]
b. 4 Mar 1855 d. 11 Nov 1918
12
William Orion King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.8.12]
b. 26 Feb 1857 d. 9 Jun 1930 [
=>
]
11
John Noyes King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.9]
b. 17 Dec 1817 d. 5 Feb 1880
Martha Sweet
b. 3 May 1822 d. 19 Jun 1845
12
Mary Janet King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.9.1]
b. 14 Dec 1839 d. 31 Jan 1915 [
=>
]
12
John Wesley King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.9.2]
b. 1 Nov 1841 d. 1 Sep 1908 [
=>
]
12
Edward R King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.9.3]
b. 10 Mar 1844 d. 19 Nov 1895
Nancy Adeline Eddy
b. 19 Apr 1828 d. 6 Feb 1901
12
Samuel Monson King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.9.4]
b. 23 Jan 1848 d. 1 Feb 1848
12
George L King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.9.5]
b. 1849
12
Albin Eugene King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.9.6]
b. 25 Jan 1851 d. 14 Jun 1929 [
=>
]
12
Harvey Elwin King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.9.7]
b. 9 Apr 1852 d. 11 Sep 1888 [
=>
]
12
Harriet Agnes King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.9.8]
b. 23 Apr 1855 d. 27 Aug 1922 [
=>
]
12
Clara Florence King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.9.9]
b. 21 Apr 1857 d. 21 Dec 1934 [
=>
]
11
Emmeline King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.10]
b. 3 Jun 1821 d. 1 Jun 1905
Moses Adams
b. 14 Dec 1814 d. 1893
12
Albert Martin Adams
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.10.1]
b. 10 Apr 1843
12
Charles Wood Adams
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.10.2]
b. 14 May 1847 d. 10 Mar 1930 [
=>
]
12
George W Adams
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.10.3]
b. 12 Feb 1851 [
=>
]
12
Josephine Adams
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.10.4]
b. 6 Dec 1856
12
Eugene Adams
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.4.10.5]
b. 6 Dec 1856 d. 29 Jan 1875
+
Jesse H King
b. 28 Oct 1781 d. 1860
10
Abigail Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.5]
b. 26 May 1783 d. 22 Feb 1835
Jesse H King
b. 28 Oct 1781 d. 1860
11
Aaron Noyes King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.5.1]
b. 31 Jul 1806 d. 6 Jun 1870
Sarah Pierpont Ayres
b. 4 Feb 1807 d. 27 Jul 1845
12
Sarah Mariah King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.5.1.1]
b. 21 Mar 1830 d. 2 Apr 1850
12
Henry Hamlin King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.5.1.2]
b. 26 Oct 1831 d. 12 Aug 1853
12
Elizabeth Fellows King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.5.1.3]
b. 26 Jun 1833 d. 26 May 1847
12
Harriet Jones King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.5.1.4]
b. 24 Oct 1834 d. 9 Feb 1896 [
=>
]
12
Jane Eliza Gibson King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.5.1.5]
b. 4 Feb 1836 d. 27 Feb 1854
12
Charles Gutsloff King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.5.1.6]
b. 20 Jul 1837 d. 23 Dec 1854
12
Mary Ann Ingersol King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.5.1.7]
b. 18 Nov 1838 d. 28 Dec 1901 [
=>
]
12
Abigail Noyes King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.5.1.8]
b. 20 Mar 1840 d. 20 Mar 1913
12
Jesse Gustavus King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.5.1.9]
b. 13 Jun 1841 d. 28 Feb 1914 [
=>
]
12
Alice Amelia King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.5.1.10]
b. 16 Mar 1843 d. 5 Jul 1883 [
=>
]
12
Albert Kappel King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.5.1.11]
b. 2 May 1844 d. 19 Jun 1913 [
=>
]
12
Son King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.5.1.12]
b. 1845 d. 1845
Delia Norton
b. 1 Apr 1818 d. 25 Aug 1902
12
Chauncey Lewis King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.5.1.13]
b. 27 Nov 1846 d. Bef 1900 [
=>
]
12
LeGrande Morse King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.5.1.14]
b. 24 Jan 1848 d. 12 Sep 1918 [
=>
]
12
Almira Kent King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.5.1.15]
b. 22 Jan 1852 d. 21 Aug 1925 [
=>
]
12
Emerson Willard King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.5.1.16]
b. 26 Apr 1854 d. 16 Nov 1927 [
=>
]
12
Frank Leslie King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.5.1.17]
b. 25 Nov 1856 d. 12 Aug 1930 [
=>
]
12
Grace Isabelle King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.5.1.18]
b. 16 Jul 1861 d. 19 Jul 1943 [
=>
]
11
John Noyes King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.5.2]
b. 14 Jul 1808
11
Mason Burnard King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.5.3]
b. 25 Apr 1810 d. 22 Oct 1869
Maritta Albro
b. 13 Apr 1813 d. 3 Sep 1886
12
Nathaniel King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.5.3.1]
b. 30 Apr 1836 d. 17 Jun 1927 [
=>
]
12
Daniel King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.5.3.2]
b. Abt 1835
12
Helen King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.5.3.3]
b. Abt 1838 d. 1931 [
=>
]
12
Adelbert King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.5.3.4]
b. Abt 1841
12
David King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.5.3.5]
b. Abt 1843
12
George King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.5.3.6]
b. Abt 1845
12
Wesley King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.5.3.7]
b. Abt 1847
12
Evelyn Jerucia King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.5.3.8]
b. 9 Feb 1849 d. 19 May 1916 [
=>
]
12
Burnard King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.5.3.9]
b. Abt 1851
12
Henry King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.5.3.10]
b. Abt 1853
12
Gilmore King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.5.3.11]
b. Abt 1855
12
Susan King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.5.3.12]
b. Abt 1856
11
Lydia King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.5.4]
b. 11 Apr 1812 d. 2 Feb 1877
Amos Wright
b. 9 Nov 1794 d. 29 Dec 1849
12
James Harvey Wright
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.5.4.1]
b. 1840 d. Feb 1866 [
=>
]
12
Walter Wright
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.5.4.2]
b. 1844
11
Thomas King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.5.5]
b. Abt 1814
11
Jesse H King, Jr
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.5.6]
b. 1815 d. 1 May 1841
11
Cyrus N King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.5.7]
b. 1817 d. 14 Jun 1833
11
Delia H King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.5.8]
b. 10 Jan 1820 d. 27 Sep 1884
Lucius E Hubbard
b. 1 May 1816 d. 16 Apr 1880
12
Alice King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.5.8.1]
b. 1843
10
Betsy Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.6]
b. 5 Jul 1786
+
John Lyons
b. Abt 1782
10
John Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.7]
b. 19 Jul 1789 d. 19 Oct 1856
Abigail Moody
b. 28 Jan 1793 d. 13 Feb 1861
11
Elizabeth M Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.7.1]
b. 21 Dec 1812 d. 23 Dec 1891
John King
b. Abt 1807 d. 21 Sep 1878
12
Lois Cordelia King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.7.1.1]
b. 12 Jul 1835 [
=>
]
12
Milton J King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.7.1.2]
b. 10 May 1839 d. 23 Jun 1867 [
=>
]
12
Lura A King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.7.1.3]
b. 20 Apr 1841 d. 11 Apr 1933 [
=>
]
12
Almon L King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.7.1.4]
b. Abt 1843
12
David C King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.7.1.5]
b. 10 Mar 1847 d. 4 Apr 1925 [
=>
]
12
Aaron B King
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.7.1.6]
b. Abt 1849
11
Mahala Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.7.2]
b. 4 Sep 1815 d. 1 May 1865
11
John Moody Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.7.3]
b. 2 Jun 1817
Elvira Friendly Chandler
b. 23 Nov 1818
12
Orianna Helen "Annie" Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.7.3.1]
b. 16 Jun 1845
12
Eugene H Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.7.3.2]
b. 14 Jul 1847 d. 23 Sep 1848
12
Orville Gould Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.7.3.3]
b. 5 Jul 1863 [
=>
]
11
Cyrus N Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.7.4]
b. 19 Jul 1819 d. 1897
Almira M Lothrop
b. 1820
12
Idella Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.7.4.1]
b. 1845
12
Mary L Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.7.4.2]
b. 1847
12
Velma Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.7.4.3]
b. 1849
12
Lillienne Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.7.4.4]
b. 1851
11
Joshua W Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.7.5]
b. 20 Jul 1823 d. 6 Jul 1878
Clara Carter
b. 1825
12
Ella Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.7.5.1]
b. 1849
12
Clara Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.7.5.2]
b. 1852
11
Washington M Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.7.6]
b. 11 Feb 1827
Lucy Pool
b. Abt 1827
12
Mary Philinda Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.7.6.1]
b. 6 Oct 1848
12
Ellen E Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.7.6.2]
b. 12 Mar 1851
12
Marcellus C Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.7.6.3]
b. 4 Aug 1853 [
=>
]
12
Eugene Hamilton Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.7.6.4]
b. 29 Jan 1856 d. 1 Jun 1915 [
=>
]
12
George O Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.7.6.5]
b. 24 Mar 1858
+
Emeline Brown
b. 26 Jun 1826 d. 12 May 1880
11
Abigail M Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.7.7]
b. 16 Jun 1835
+
George Ballou
b. 4 Jun 1829 d. 31 Jan 1882
10
Enoch Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.8]
b. 19 Oct 1795 d. 29 Dec 1854
Mary Ann Knox
b. 1798 d. 15 Oct 1859
11
David Knox Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.8.1]
b. 22 Oct 1820 d. 24 Nov 1900
Lucinda Barnes
b. Abt 1827
12
Clara L Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.8.1.1]
b. 26 May 1849
12
David W K Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.8.1.2]
b. 6 May 1851
12
Arthur H Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.8.1.3]
b. 15 Apr 1853
12
Rolla E Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.8.1.4]
b. 18 Jul 1855 [
=>
]
11
Aaron Alonzo Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.8.2]
b. 22 Nov 1822
Maria Celesta Crandall
b. 25 Apr 1821 d. 11 Jun 1861
12
Emma E Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.8.2.1]
b. 9 May 1852 d. 5 Apr 1853
12
Alice Maud Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.8.2.2]
b. 19 Dec 1853 d. 4 Sep 1892
12
Willis Alonzo Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.8.2.3]
b. 14 May 1855 d. 26 Jan 1875
12
Robert Bruce Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.8.2.4]
b. 25 May 1857 d. 9 Oct 1857
12
Rolla Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.8.2.5]
b. 3 Nov 1860 d. 29 Apr 1861
11
William W Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.8.3]
b. 25 Mar 1825 d. 6 Dec 1855
11
Mary A Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.8.4]
b. 26 Jul 1828
11
Amanda M Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.8.5]
b. 15 Jan 1831 d. 16 Feb 1873
11
Silon Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.8.6]
b. 30 Nov 1832 d. 18 Jan 1875
Maria Thompkins
b. 1835
12
Mary A Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.8.6.1]
b. 1859
12
Alice D Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.8.6.2]
b. Feb 1861
12
Harper S Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.8.6.3]
b. 7 Dec 1868
11
Lydia A Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.8.7]
b. 8 Jul 1834 d. 25 Apr 1891
11
Henry C Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.8.8]
b. 23 Apr 1836
Ann Elizabeth Taylor
b. Abt 1854
12
Clifford Henry Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.8.8.1]
b. 22 Apr 1879
11
Robert B Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.8.9]
b. 9 Mar 1838 d. 5 Feb 1854
10
Cyrus C Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.9]
b. 2 Dec 1797 d. 1859
Louisa Lester
b. 1801
11
William S Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.9.1]
b. 11 Apr 1824
+
Alice A Tallmadge
11
Mortimer Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.9.2]
b. 19 Nov 1845
12
Mortimer Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.9.2.1]
b. 31 Mar 1873
Mary A Jones
b. Abt 1812
11
Mortimer Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.6.9.3]
b. 19 Nov 1854 d. 19 Nov 1872
9
Moses Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.7]
b. 31 Aug 1756 d. 1757
9
Moses Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.8]
b. 23 Oct 1758 d. 4 Aug 1805
+
Sarah Manuel
b. 1755
9
Nathan Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.9]
b. 24 Feb 1761 d. 15 Sep 1825
Sarah Thompson
b. 14 Jun 1760 d. 7 Nov 1832
10
Nathan Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.9.1]
b. 24 May 1782 d. 6 Aug 1856
10
William Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.9.2]
b. 6 Jul 1784 d. 20 Oct 1865
10
James S Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.9.3]
b. 20 Aug 1786 d. 1818
Cynthia Kingsbury
b. 25 May 1794 d. 30 Mar 1873
11
Jason N Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.9.3.1]
b. 23 Apr 1819 d. 27 Apr 1894
Mary Taylor
b. 29 Jan 1830 d. 3 Oct 1906
12
Ida Bell Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.9.3.1.1]
b. 4 Aug 1853 d. 2 Feb 1935 [
=>
]
12
Clara Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.9.3.1.2]
b. 15 Sep 1854 d. 18 Dec 1920 [
=>
]
12
Oscar Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.9.3.1.3]
b. 13 Dec 1857 d. 2 Jan 1940 [
=>
]
12
Jesse Milo Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.9.3.1.4]
b. 28 Apr 1867 d. 15 Jan 1915 [
=>
]
11
James Solon Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.9.3.2]
b. 30 Dec 1821
Cynthia D Know
b. 1825
12
Nellie Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.9.3.2.1]
b. 27 Apr 1852
12
Ida M Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.9.3.2.2]
b. 12 Nov 1854
12
Lizzie E Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.9.3.2.3]
b. 12 Oct 1856 d. 23 Feb 1926 [
=>
]
11
Emily K Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.9.3.3]
b. 13 Feb 1824
11
Charles H Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.9.3.4]
b. 10 Jan 1826 d. Oct 1911
Lucy Coolidge Hazelton
b. 12 Apr 1833 d. 8 Jul 1921
12
Charles Thomas Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.9.3.4.1]
b. 13 Jun 1851 d. Jun 1921 [
=>
]
12
Harriet Emma Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.9.3.4.2]
b. 20 Sep 1853
12
Sidney Marriell Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.9.3.4.3]
b. 8 Dec 1854 d. 1864
12
Fred Buzzell Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.9.3.4.4]
b. 3 Aug 1857 d. 31 Dec 1946 [
=>
]
11
Hezekiah H Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.9.3.5]
b. 22 Feb 1828
+
Seraphina Larned Dow
b. 8 Jan 1828 d. 19 Oct 1854
Emily Chandler
b. 1836
12
Horace W Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.9.3.5.1]
b. 24 Oct 1857 [
=>
]
12
Charles B Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.9.3.5.2]
b. 12 May 1860 d. 9 Aug 1882
12
Nathaniel K Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.9.3.5.3]
b. 16 Jan 1865 [
=>
]
12
Mary M Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.9.3.5.4]
b. 8 Mar 1875
11
George H Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.9.3.6]
b. 30 Apr 1832 d. 12 May 1864
11
Caroline Jane Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.9.3.7]
b. 9 Jan 1836 d. 3 Nov 1919
Lemuel Augustus Chandler
b. 26 Jul 1831 d. 5 Nov 1888
12
Carrie Augusta Chandler
[1.5.2.3.10.3.1.1.9.3.7.1]
b. 7 Feb 1861 d. 29 Apr 1935 [
=>
]
12
Wilber Chandler
[1.5.2.3.10.3.1.1.9.3.7.2]
b. 30 Jan 1862 d. 17 Nov 1862
12
Annie Louise Chandler
[1.5.2.3.10.3.1.1.9.3.7.3]
b. 20 Mar 1863 d. 1 May 1920 [
=>
]
12
Hattie G Chandler
[1.5.2.3.10.3.1.1.9.3.7.4]
b. 25 May 1864
12
Frank Augustus Chandler
[1.5.2.3.10.3.1.1.9.3.7.5]
b. 14 Aug 1865 d. Jul 1872
12
Henry Chandler
[1.5.2.3.10.3.1.1.9.3.7.6]
b. 25 Sep 1866 d. 27 Dec 1866
12
Ida May Chandler
[1.5.2.3.10.3.1.1.9.3.7.7]
b. 8 May 1869 d. 6 Feb 1935
12
Ernest Chandler
[1.5.2.3.10.3.1.1.9.3.7.8]
b. 11 Jun 1870
12
Elizabeth Ella Chandler
[1.5.2.3.10.3.1.1.9.3.7.9]
b. 26 Feb 1872 d. 14 Dec 1955
12
Mary Adeline Chandler
[1.5.2.3.10.3.1.1.9.3.7.10]
b. 9 Sep 1876 d. 25 Dec 1951
12
Harry Augustus Chandler
[1.5.2.3.10.3.1.1.9.3.7.11]
b. 26 Dec 1880 d. 31 Dec 1962
+
Ann J Hoyt
b. Abt 1825
10
Amos Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.9.4]
b. 13 Aug 1788 d. 5 Aug 1877
10
Aaron Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.9.5]
b. 30 Sep 1790 d. 21 Oct 1820
Laura K Noyes
b. 14 Jun 1799 d. 11 Dec 1844
11
Aaron G Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.9.5.1]
b. Abt 1824
10
Richard Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.9.6]
b. 30 Mar 1793 d. 15 Aug 1825
10
Samuel Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.9.7]
b. 4 Jul 1795 d. Oct 1867
10
Salley Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.1.9.8]
b. 21 Nov 1798
8
Benjamin Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2]
b. 20 Dec 1721 d. 27 Aug 1748
Sarah Pickard
b. 18 May 1723 d. 25 Aug 1748
9
Sarah Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.1]
b. 14 Mar 1745 d. 12 Feb 1824
George Jewett
b. 18 Mar 1747 d. 5 May 1829
10
Sarah Jewett
[1.5.2.3.10.3.1.2.1.1]
b. 11 Jan 1772
10
Susannah Jewett
[1.5.2.3.10.3.1.2.1.2]
b. 5 Jun 1773
10
Hannah Jewett
[1.5.2.3.10.3.1.2.1.3]
b. 25 Oct 1774
10
Lucy Jewett
[1.5.2.3.10.3.1.2.1.4]
b. 2 Aug 1776
10
Dolly Jewett
[1.5.2.3.10.3.1.2.1.5]
b. 26 Jun 1779
9
Johnathan Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2]
b. 9 Feb 1746 d. 8 Aug 1831
Elizabeth Platt
b. 1748
10
Benjamin Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.1]
b. 30 Sep 1766 d. Jan 1859
Lois Turner
b. 1770 d. 28 Jan 1830
11
Abiel Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.1.1]
b. 13 Jan 1792
11
Susanna Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.1.2]
b. 8 Jan 1796
11
Lois Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.1.3]
b. 18 Apr 1800
11
Joseph Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.1.4]
b. 16 Mar 1804
10
Jonathan Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.2]
b. 10 Jun 1768 d. 1845
10
Moses Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3]
b. 14 Feb 1770 d. 5 Mar 1846
Sarah Currier
b. 29 Jul 1770 d. 17 Aug 1848
11
Daniel Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.1]
b. 25 Jan 1797 d. 11 Mar 1864
Susannah Cooper
b. 2 Jun 1797 d. 10 Oct 1878
12
Isaiah Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.1.1]
b. 21 Oct 1816 d. 11 Sep 1898 [
=>
]
12
Ephraim Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.1.2]
b. 1818 d. 1889 [
=>
]
12
Lydia Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.1.3]
b. Jul 1820 [
=>
]
12
Nathaniel Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.1.4]
b. 9 Jul 1822 d. 26 Oct 1905 [
=>
]
12
Sarah Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.1.5]
b. 1825 d. 1886
12
Moses Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.1.6]
b. 1827 d. 1865
12
Charles Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.1.7]
b. 1830 d. 1901
12
Susan Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.1.8]
b. 1831 d. 1861
12
Hannah Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.1.9]
b. 1832
12
Eliza Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.1.10]
b. 1834
12
Albert Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.1.11]
b. 1838 d. 1865
12
Margaret Augusta Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.1.12]
b. 25 Dec 1839 d. 4 Dec 1932 [
=>
]
12
Daniel Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.1.13]
b. 1842
11
Lydia Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.2]
b. 11 Mar 1798
+
Rufus Rowe
b. 15 May 1796 d. 15 May 1865
11
Martha Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.3]
b. 25 Sep 1800 d. 17 Aug 1848
James Rowe
b. 20 Feb 1791 d. 14 Apr 1857
12
Hiram Rowe
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.3.1]
b. Abt 1819
12
Levi Rowe
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.3.2]
b. 1822 d. 22 Aug 1851 [
=>
]
12
Uriah Taylor Rowe
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.3.3]
b. 28 Jun 1824 d. 8 Oct 1890 [
=>
]
12
Hannah N Rowe
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.3.4]
b. 26 Jul 1827
12
James Noyes Rowe
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.3.5]
b. Abt 1829
12
Lydia Margaret Rowe
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.3.6]
b. 16 Aug 1832 d. 18 Feb 1860 [
=>
]
12
Ann Caroline Rowe
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.3.7]
b. 26 Sep 1834 d. 17 May 1854
12
Daniel R Rowe
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.3.8]
b. 27 Sep 1837 d. Jul 1863
12
Melissa Jane Rowe
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.3.9]
b. 20 Dec 1840
12
Albert Eli Rowe
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.3.10]
b. 25 Jun 1843
11
Frances "Fanny" Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.4]
b. 28 Jul 1802 d. 15 Feb 1884
Peter Philbrick
b. 26 Mar 1798 d. 9 May 1871
12
Susan N Philbrick
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.4.1]
b. 13 Dec 1822 d. 14 Jul 1885
12
Mehitable B Philbrick
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.4.2]
b. 15 Jan 1827 d. 18 Dec 1893
12
George W P Philbrick
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.4.3]
b. 10 Dec 1828 d. 15 Apr 1913 [
=>
]
12
Sarah Annie Philbrick
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.4.4]
b. 6 Nov 1830 d. 13 Dec 1906
12
Sylvia H Philbrick
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.4.5]
b. 4 Aug 1832 d. 15 Dec 1865 [
=>
]
12
Rachel M Philbrick
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.4.6]
b. 23 Apr 1834
12
Rhadamanthus Philbrick
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.4.7]
b. 8 Sep 1836 d. 14 Nov 1925
12
Frances G Philbrick
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.4.8]
b. 7 Apr 1840 d. 19 Apr 1882 [
=>
]
12
Caroline Evangeline Philbrick
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.4.9]
b. 30 May 1843 d. 2 Jun 1919 [
=>
]
12
Lizzie B Philbrick
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.4.10]
b. 18 Jul 1845 d. 9 Oct 1909 [
=>
]
12
Mary C Philbrick
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.4.11]
b. 18 Jul 1845 d. 3 Mar 1886
12
Chandler Noyes Philbrick
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.4.12]
b. 21 Jun 1824 d. 14 May 1866 [
=>
]
11
Susanna Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.5]
b. 4 Jun 1804
11
Hezekiah Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.6]
b. 1 Sep 1807 d. 30 May 1846
Mary W Walker
b. Abt 1810
12
Abram W Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.6.1]
b. 12 Jul 1831 d. 15 Oct 1894 [
=>
]
12
James Abram Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.6.2]
b. 27 Sep 1837 [
=>
]
12
Lydia Ann Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.6.3]
b. 29 Mar 1833 bur. 23 Sep 1909 [
=>
]
12
Eli Pierce Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.6.4]
b. 12 Jul 1835 d. 11 Jul 1884 [
=>
]
12
Danvill Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.6.5]
b. 3 Jul 1840 [
=>
]
12
Alvanus Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.6.6]
b. 27 Dec 1842 d. 1895 [
=>
]
12
Hezekiah Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.6.7]
b. 17 Jul 1846 [
=>
]
11
Chandler Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.7]
b. 20 Aug 1810 d. 1878
Abigail Perkins
b. Abt 1815
12
Martha Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.7.1]
b. Abt 1837
12
Eli Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.7.2]
b. Abt 1838 d. 1864
12
Cyrus S Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.7.3]
b. 26 May 1839 d. 8 Sep 1916 [
=>
]
12
Hubbard Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.7.4]
b. Abt 1841
12
Mary Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.7.5]
b. Abt 1843
12
Henry Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.7.6]
b. Abt 1845
11
Eli Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.8]
b. 27 Apr 1814 d. 10 Sep 1854
Clementina Pierce
b. 1817 d. 1901
12
Columbia P Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.8.1]
b. 1836 d. 6 Jun 1890 [
=>
]
12
Eusebeus H Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.8.2]
b. 28 Nov 1846 d. 24 May 1893 [
=>
]
12
Luther Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.8.3]
b. 1849
11
Isaiah Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.9]
b. 20 Nov 1816
11
Hannah Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.3.10]
+
Jeremiah Rowe
b. 25 Jun 1799
10
Nathaniel Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.4]
b. 16 Dec 1771 d. 26 Nov 1854
Annie Currier
b. Abt 1773
11
Mary Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.4.1]
b. 7 Jan 1799 d. 2 Jul 1866
+
Ezekial Potter
11
Abram Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.4.2]
b. 3 Mar 1803 d. 1877
Polly Decker
b. Abt 1805
12
William P Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.4.2.1]
b. 28 Jul 1834 [
=>
]
12
Hannah Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.4.2.2]
b. 27 Feb 1838
12
Albert D Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.4.2.3]
b. 11 Jun 1840 d. 20 Nov 1876
12
Son Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.4.2.4]
b. 1842
11
Sarah Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.4.3]
b. Sep 1806 d. 1827
11
Son Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.4.4]
b. 1808
11
Son Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.4.5]
b. 1810
10
Sally Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.5]
b. 9 Jun 1772 d. 1 Jul 1831
Samuel Little
b. 2 Sep 1772 d. 20 Dec 1849
11
Susan Little
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.5.1]
b. 10 Nov 1800 d. 9 Feb 1871
+
John G Savage
b. Abt 1796
11
John Little
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.5.2]
b. 27 Jun 1802 d. 16 Jun 1877
11
Moses Little
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.5.3]
b. 6 May 1803 d. 9 Apr 1829
11
David Little
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.5.4]
b. 11 Nov 1804 d. 29 Sep 1827
11
Eli Little
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.5.5]
b. 5 Jun 1806 d. 17 Feb 1887
Mary Bailey
b. 5 Jun 1815
12
Elizabeth Little
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.5.5.1]
b. 29 Jul 1830
12
Evalina Jewett Little
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.5.5.2]
b. 17 Feb 1841 d. 30 Aug 1917 [
=>
]
12
Sarah Tamson Little
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.5.5.3]
b. 5 Nov 1838 [
=>
]
12
Mary Luetta Little
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.5.5.4]
b. 16 Sep 1843 d. 11 Jun 1916 [
=>
]
12
Julia Ann Little
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.5.5.5]
b. 1 Jun 1846
12
Eli Laureston Little
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.5.5.6]
b. 6 Mar 1850
12
Ella Elizabeth Little
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.5.5.7]
b. 16 Jul 1852
12
Moses Franklin Little
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.5.5.8]
b. 6 Feb 1855 [
=>
]
12
Laura Jane Little
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.5.5.9]
b. 29 May 1858 d. 18 Apr 1863
11
Sarah Little
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.5.6]
b. 5 Jun 1809 d. 11 Mar 1831
11
Samuel Little
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.5.7]
b. 3 Jun 1811 d. Abt 1895
Hannah J Boynton
b. 7 May 1813 d. 1900
12
Melissa A Little
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.5.7.1]
b. 1849 d. 1936
12
Xenophan John Little
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.5.7.2]
11
Mary Ann Little
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.5.8]
b. 18 Feb 1813 d. 2 Aug 1876
Thomas Boynton
b. 1 Nov 1812 d. 26 Feb 1903
12
Rebecca A Boynton
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.5.8.1]
b. 1841 d. 3 Nov 1877
12
Cyrus E Boynton
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.5.8.2]
b. 1843 d. 1927
12
Oscar Wilson Boynton
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.5.8.3]
b. 22 May 1845 d. 21 Apr 1924
12
Eli L Boynton
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.5.8.4]
b. 12 Aug 1847 d. 14 May 1941
12
Elen M Boynton
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.5.8.5]
b. 1850
12
Alpheus Boynton
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.5.8.6]
b. 1853
11
Julia Little
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.5.9]
b. 14 Jan 1815 d. 12 Feb 1819
11
Hannah Sylvester Little
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.5.10]
b. 26 Jul 1816 d. Abt 1857
10
Lydia Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.6]
b. Abt 1773
+
Abijah Little
10
John Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.7]
b. 22 Apr 1782
Margaret Lash
b. 28 Nov 1785 d. 25 Mar 1840
11
Hiram Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.7.1]
b. 8 Aug 1807
+
Josephine Jones
b. 1810
11
Rachel Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.7.2]
b. 22 Oct 1809
11
Aaron Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.7.3]
b. 10 Jul 1812
11
Paul Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.7.4]
b. 1 Jun 1814
11
Margaret Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.7.5]
b. 17 Nov 1816 d. 5 May 1856
Cowell Hatch
b. 29 Jul 1814 d. 30 Jan 1858
12
Edwin Hatch
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.7.5.1]
b. 19 Oct 1840 d. 30 Aug 1842
12
Ann Eliza Hatch
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.7.5.2]
b. 6 Feb 1842 d. 28 Aug 1902 [
=>
]
12
Caroline Hatch
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.7.5.3]
b. 5 Nov 1843 d. 4 Feb 1844
12
Aldana Hatch
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.7.5.4]
b. 28 Nov 1844 d. 12 Oct 1861
12
Henry J Hatch
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.7.5.5]
b. 16 Dec 1855 d. 4 Jul 1907
11
Abiel Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.7.6]
b. 3 Sep 1819
11
Eliza Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.7.7]
b. 27 Jan 1821
11
Balinda Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.7.8]
b. 5 Jan 1824
11
John Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.7.9]
b. 23 Apr 1826
10
Isaac Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.8]
b. 1787 d. 1845
Hannah Plummer
b. Abt 1790
11
Albert Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.8.1]
b. 27 Apr 1812
+
Margaret Johnson
11
Son Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.8.2]
b. 1814
11
Son Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.8.3]
b. 1816
11
Son Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.8.4]
b. 1818
10
Daniel Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.9]
b. Abt 1788
Mary Bradbury
b. Abt 1792
11
Lois C Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.9.1]
b. Abt 1802
+
Samuel Cockson
11
Silas Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.9.2]
b. Abt 1802
+
Hannah Shepard
10
Aaron Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.10]
b. 10 Jul 1789 d. 5 Jan 1867
Nancy Bradbury
b. Abt 1800
11
Hannah Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.10.1]
b. 1829
11
Maria L Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.10.2]
b. 6 Jun 1832 d. 16 Jun 1898
11
Lydia E Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.10.3]
b. 22 Jul 1834 d. Sep 1862
11
Aaron B Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.10.4]
b. 6 Feb 1837
Ina H Bond
b. Abt 1839
12
Clyde S Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.10.4.1]
b. Apr 1869
12
Walter D Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.10.4.2]
b. May 1872
10
Enoch Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.2.11]
b. Abt 1791
+
Hapsibah G Heath
9
Son Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.3]
b. 1748 d. 1748
9
Son Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.4]
b. 1750 d. 1750
9
Son Noyes
[1.5.2.3.10.3.1.2.5]
b. 1752 d. 1752
6
Nicholas Noyes
[1.5.2.3.10.4]
b. 22 Dec 1647 d. 13 Dec 1717
+
Elizabeth Dunster
b. Abt 1630 bur. 30 Dec 1715
6
Deacon Cutting Noyes
[1.5.2.3.10.5]
b. 23 Sep 1649 d. 25 Oct 1734
6
James Noyes
[1.5.2.3.10.6]
b. 16 May 1657 d. Aft 22 Apr 1723
5
John Noyes
[1.5.2.3.11]
c. 27 Mar 1617 d. Aft 24 Jul 1660
Elizabeth Bulpit
b. Abt 1622
6
Simon Noyes
[1.5.2.3.11.1]
c. 19 Feb 1641
6
Mary Noyes
[1.5.2.3.11.2]
c. 10 May 1643
6
Bridgat Noyes
[1.5.2.3.11.3]
c. 4 Dec 1656
4
Marie Parker
[1.5.2.4]
b. 1577
4
Cuthbert Parker
[1.5.2.5]
b. 1577 d. 8 Jul 1636
4
Edward Parker
[1.5.2.6]
b. 1581 d. Aft 1631
4
William Parker
[1.5.2.7]
b. Abt 1591
3
Thomas Parker
[1.5.3]
b. 1 Jan 1559 d. 3 Mar 1634
3
Rogerus Parker
[1.5.4]
b. 1561 d. 29 Aug 1629
3
William Parker
[1.5.5]
b. 23 Mar 1561 d. 25 May 1631
3
Jane Parker
[1.5.6]
c. 10 Oct 1568