Home Page
|
What's New
|
Photos
|
Histories
|
Headstones
|
Reports
|
Surnames
Search
First Name:
Last Name:
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Suomalainen
Svenska
Agnes Williams
- 1486
Submit Photo / Document
Individual
Descendants
Relationship
Timeline
Submit Photo / Doc
Worksheet
Family
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Agnes Williams
[1]
d. 22 Jun 1486
John Milner
b. 1443 d. 22 Jun 1486
2
Thomas Milner
[1.1]
b. 1470 d. 1565
Emmot Millner
b. Abt 1470
3
William Milner
[1.1.1]
b. Abt 1495 d. 1560
3
George Milner
[1.1.2]
b. 1500 d. 1590
3
Agnes Milner
[1.1.3]
b. Abt 1500
3
Margery Milner
[1.1.4]
b. Abt 1500
3
Thomas Milner
[1.1.5]
b. Abt 1500
3
Margaret Milner
[1.1.6]
b. 1514 d. 18 Mar 1617
Nicholas Taft
b. 1514
4
Robert Taft
[1.1.6.1]
b. 1534 d. 9 Sep 1590
Margaret Fane
b. 1538 d. 1584
5
Nicholas Taft
[1.1.6.1.1]
b. 1584 d. 1 Jan 1629
Margaret Milner
b. 13 Oct 1587 d. 18 Mar 1627
6
Richard Robert Taft
[1.1.6.1.1.1]
b. 1614 d. 1700
Margaret Faun
b. 1620 d. 1685
7
Robert Taft
[1.1.6.1.1.1.1]
b. 1640 d. 8 Feb 1725
Sarah Simpson
b. 1640 d. 8 Nov 1726
8
Thomas Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1]
b. 1671 d. 1755
Deborah Chenery
b. 9 Jun 1671 d. 9 Aug 1747
9
Joseph Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1]
b. 26 May 1693 d. 20 Oct 1761
Hannah Cook
b. 29 Sep 1695 d. 2 Aug 1771
10
Aaron Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.1]
b. 26 Aug 1721 d. 4 Nov 1722
10
Joseph Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.2]
b. 15 Jan 1724 d. 1 Feb 1803
Elisabeth Cummings
d. 27 Aug 1770
11
Thomas Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.2.1]
b. 19 Aug 1754
11
Elisabeth Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.2.2]
b. 1 Jul 1756 d. 4 Sep 1797
11
Nathan Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.2.3]
b. 3 Jun 1758
11
Phebe Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.2.4]
b. 26 Nov 1760
+
Aaron Balkam
b. 1760 d. 1842
11
Eunice Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.2.5]
b. 11 Feb 1761 d. 1833
11
Hannah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.2.6]
b. 1 Nov 1763 d. 3 Jul 1832
Eastman Taft
b. 16 Jun 1763 d. 29 Apr 1829
12
Chloe Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.2.6.1]
b. 7 Jul 1785 d. 25 Apr 1826 [
=>
]
12
Ezra Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.2.6.2]
b. 6 Mar 1793 d. 19 Feb 1808
11
Leonard Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.2.7]
b. 29 Mar 1767 d. 6 Feb 1846
Asenah Thayer
b. 7 Dec 1769 d. 22 Jul 1824
12
Willard Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.2.7.1]
b. 25 Aug 1791 d. 25 Feb 1832 [
=>
]
12
Joseph Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.2.7.2]
b. 14 Oct 1793 d. 20 Dec 1869 [
=>
]
12
Duty Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.2.7.3]
b. 30 Jun 1796 d. 22 Oct 1830 [
=>
]
11
Cummings Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.2.8]
b. 27 Aug 1770 d. 22 Jun 1841
Marcy Green
b. 1 Jan 1760 d. 8 Jun 1815
12
Ezra Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.2.8.1]
b. 13 May 1797 d. 16 Nov 1878 [
=>
]
12
Benjamin Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.2.8.2]
b. 10 Aug 1798 d. 29 May 1799
12
Benjamin Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.2.8.3]
b. 6 May 1800 d. 17 Oct 1828 [
=>
]
12
Hannah G Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.2.8.4]
b. 18 May 1802 d. 8 Jan 1843 [
=>
]
10
Hannah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.3]
b. 16 Nov 1725 d. 4 Nov 1822
Peter Keith
b. 23 Apr 1727 d. 1790
11
Joseph Keith
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.3.1]
b. 20 Jul 1749
11
Debora Keith
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.3.2]
b. 2 May 1751
11
Hannah Keith
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.3.3]
b. 17 Jul 1753 d. 2 Apr 1842
Joseph Taft
b. 6 Jul 1751 d. 2 Jul 1828
12
Oliver Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.3.3.1]
b. 6 Nov 1771 d. 20 Feb 1853 [
=>
]
12
Huldah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.3.3.2]
b. 17 Feb 1775 d. Bef 21 May 1780
12
Huldah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.3.3.3]
b. 21 May 1780 d. 11 Oct 1811 [
=>
]
12
Hannah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.3.3.4]
b. 29 Sep 1783
12
Peter Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.3.3.5]
b. 24 Apr 1786
11
Mary Keith
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.3.4]
b. 17 Sep 1755
11
Esther Keith
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.3.5]
b. 23 Jan 1758 d. 4 Oct 1761
11
Peter Keith
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.3.6]
b. 3 May 1760
+
Esther Alton
b. 23 Jun 1756
11
Barak Keith
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.3.7]
b. 25 Aug 1762 d. 26 Mar 1833
11
Marshal Keith
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.3.8]
b. 4 May 1765 d. 1817
11
Stephen Keith
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.3.9]
b. 24 Aug 1768
10
Noah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.4]
b. 1726 d. 2 Sep 1814
Margaret Keith
b. 1733 d. 1803
11
Deborah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.4.1]
b. 30 Sep 1753
+
Samuel Penniman
b. 1 Dec 1748
11
Timothy Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.4.2]
b. 16 Feb 1755 d. 16 Nov 1827
Abigail Wright
b. 29 Nov 1754 d. 22 Nov 1840
12
Mary Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.4.2.1]
b. 20 Jan 1780 d. 15 Nov 1863 [
=>
]
12
Sullivan Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.4.2.2]
b. 4 Sep 1781 d. 20 Mar 1865 [
=>
]
12
Adolphus Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.4.2.3]
b. 10 Jul 1784 d. 8 Feb 1857 [
=>
]
12
David Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.4.2.4]
b. 1 Jan 1786
12
Joseph Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.4.2.5]
b. 26 Jun 1791 d. 15 May 1865
11
Emmeline Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.4.3]
b. Abt 1757
11
Noah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.4.4]
b. 14 Jan 1758 d. 25 Feb 1828
Charlotte Arnold
b. 4 Sep 1771 d. 5 Feb 1848
12
Almira Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.4.4.1]
b. 9 Jun 1800 d. 1873 [
=>
]
12
Arnold Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.4.4.2]
b. 3 Feb 1793 d. 4 Feb 1865 [
=>
]
12
Noah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.4.4.3]
b. 1795 d. 31 Oct 1869
12
Charlotte A Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.4.4.4]
b. 1796
12
Daniel O Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.4.4.5]
b. 1797 d. 11 May 1871
12
Susanna Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.4.4.6]
b. 1798 d. 1875
12
Mary A Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.4.4.7]
b. 1802 d. 23 May 1804
12
Olive Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.4.4.8]
b. 1804
11
Keith Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.4.5]
b. 1761 d. 10 Sep 1825
11
Chloa Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.4.6]
b. 25 Nov 1763 d. 4 May 1783
Eastman Taft
b. 16 Jun 1763 d. 29 Apr 1829
12
Eastman Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.4.6.1]
b. 2 May 1783 d. 8 Aug 1857
11
Micajah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.4.7]
b. 8 Mar 1766 d. 9 Sep 1849
11
Charlotte Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.4.8]
b. 10 Jun 1768
11
David Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.4.9]
b. 1770 d. 5 May 1832
11
Gersham Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.4.10]
b. 1772
11
Joseph Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.4.11]
b. 1772 d. 23 Aug 1830
11
Charlotte Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.4.12]
b. 1774 d. 21 Jan 1777
10
Ezra Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.5]
b. 15 Apr 1731 d. 1761
10
Experience Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.6]
b. 7 Apr 1733 d. 15 Mar 1817
Elisha Taft
b. 3 May 1728 d. 3 Mar 1791
11
Hannah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.6.1]
b. 16 Mar 1758
11
Elisha Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.6.2]
b. 4 Mar 1761 d. 16 Jan 1820
Mary Sadler
b. 15 Aug 1768 d. 1800
12
Hiram Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.6.2.1]
b. 2 Apr 1789 d. 15 Nov 1794
12
Elisha Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.6.2.2]
b. 23 Jul 1791 d. 26 Feb 1858
12
Ormon Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.6.2.3]
b. 11 Nov 1793 d. 23 Jan 1794
12
Mary Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.6.2.4]
b. 23 May 1795 d. 23 Feb 1875
11
Sarah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.6.3]
b. 21 Mar 1763 d. 11 Oct 1835
Ezra Wood, Jr
b. 12 Mar 1759 d. 10 May 1837
12
Ezra Wood
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.6.3.1]
b. 25 Oct 1781
12
Experience Wood
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.6.3.2]
b. 16 Mar 1783 d. 14 Oct 1818
12
Sarah Wood
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.6.3.3]
b. 7 Aug 1784
12
Elisha Wood
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.6.3.4]
b. 24 Apr 1786 d. 19 Oct 1797
12
Jonathan Wood
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.6.3.5]
b. 8 Oct 1787 d. 26 Feb 1846
12
Anna Wood
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.6.3.6]
b. 31 Aug 1789 d. 20 Mar 1832
12
Chapin Wood
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.6.3.7]
b. 2 Apr 1792
12
Lucy Wood
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.6.3.8]
b. 11 Nov 1794 d. 10 Dec 1826
12
Silva Wood
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.6.3.9]
b. 29 Apr 1796
12
Silva Wood
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.6.3.10]
b. 29 Apr 1796
12
Phila Wood
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.6.3.11]
b. 5 Jul 1798
12
Elisha Wood
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.6.3.12]
b. 7 Nov 1800
12
Simeon Wood
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.6.3.13]
b. 5 Jan 1805
11
Israel Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.6.4]
b. 12 Feb 1766
11
Joseph Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.6.5]
b. 15 Sep 1768 d. Aft 29 Sep 1815
Sarah Farrar
b. 14 Sep 1764 d. 5 Aug 1810
12
Experience
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.6.5.1]
b. 5 Feb 1792
12
Amiel F Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.6.5.2]
b. 1 Oct 1794 d. 29 Nov 1869
12
Roxalana Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.6.5.3]
b. 22 Jan 1798
12
Sofrona Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.6.5.4]
b. 17 Jun 1800
12
Esquire Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.6.5.5]
b. 28 Apr 1803 d. 11 Mar 1865
12
Deborah R Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.6.5.6]
b. 6 Jan 1806
+
Marcy Stockwell
b. Abt 1794
10
Deborah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.7]
b. 11 May 1735 d. 10 Dec 1738
10
Deborah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.1.8]
b. 12 Mar 1744 d. 10 Dec 1778
9
Sarah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.2]
b. 29 May 1695 d. 1719
Thomas Tenney
b. 28 May 1681
10
Elizabeth Tenney
[1.1.6.1.1.1.1.1.2.1]
b. Abt 1709 d. 9 Feb 1709
10
Elizabeth Tenney
[1.1.6.1.1.1.1.1.2.2]
b. 15 Jan 1713 d. Abt 1736
10
Phebe Tenney
[1.1.6.1.1.1.1.1.2.3]
b. 5 Jan 1716 d. 19 Sep 1756
9
Eleazer Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.3]
b. 5 Apr 1697 d. 29 Aug 1759
Rachel Thayer
b. 5 Mar 1700 d. 1759
10
Aaron Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.3.1]
b. 20 Jul 1722 d. 24 Apr 1764
10
Moses Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.3.2]
b. 20 Jul 1722 d. 12 Nov 1791
10
Sarah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.3.3]
b. 2 Nov 1727
10
Joshua Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.3.4]
b. 14 Jan 1731 d. 1770
9
Hanna Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.4]
b. 17 Apr 1699
9
Rebecah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.5]
b. 15 Mar 1701 d. 1748
9
Deborah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.6]
b. 14 Nov 1702 d. 9 Aug 1747
Benjamin Wheelock
b. 10 Apr 1704 d. 1777
10
Benjamin Wheelock
[1.1.6.1.1.1.1.1.6.1]
b. 17 Aug 1729 d. 16 Apr 1776
10
Jesse Wheelock
[1.1.6.1.1.1.1.1.6.2]
b. 8 Sep 1731 d. Bef 4 Sep 1781
Phoebe White
b. 8 Oct 1737 d. Mar 1783
11
Phineas Wheelock
[1.1.6.1.1.1.1.1.6.2.1]
b. 28 Apr 1754 d. 21 Jun 1759
11
Enock Wheelock
[1.1.6.1.1.1.1.1.6.2.2]
b. 14 Oct 1755
11
Mary Wheelock
[1.1.6.1.1.1.1.1.6.2.3]
b. 23 May 1756 d. 5 Nov 1807
11
Nathan Wheelock
[1.1.6.1.1.1.1.1.6.2.4]
b. 20 Apr 1758
11
Nancy Wheelock
[1.1.6.1.1.1.1.1.6.2.5]
b. 14 Nov 1767 d. 9 Oct 1843
11
Abigail Wheelock
[1.1.6.1.1.1.1.1.6.2.6]
b. 16 Jan 1772
11
Baruch Wheelock
[1.1.6.1.1.1.1.1.6.2.7]
b. 4 Jan 1774 d. 28 Mar 1816
11
Submit Wheelock
[1.1.6.1.1.1.1.1.6.2.8]
b. 10 Jan 1782 d. 29 Jan 1823
10
Jonathan Wheelock
[1.1.6.1.1.1.1.1.6.3]
b. 8 Sep 1731 d. 1774
Ruth Daniels
b. 13 Jul 1738 d. 26 Sep 1798
11
Eleazer Wheelock
[1.1.6.1.1.1.1.1.6.3.1]
b. 15 Jul 1756 d. 1841
11
Dole Wheelock
[1.1.6.1.1.1.1.1.6.3.2]
b. 29 May 1758
11
Susannah Wheelock
[1.1.6.1.1.1.1.1.6.3.3]
b. 23 Feb 1760 d. 2 May 1776
11
Lyman Wheelock
[1.1.6.1.1.1.1.1.6.3.4]
b. 30 Nov 1761 d. 29 Mar 1848
11
Alphaeus Wheelock
[1.1.6.1.1.1.1.1.6.3.5]
b. 17 Dec 1763
11
Willard Wheelock
[1.1.6.1.1.1.1.1.6.3.6]
b. 19 Jun 1768 d. 29 Mar 1823
11
Deobrah Wheelock
[1.1.6.1.1.1.1.1.6.3.7]
b. 17 Dec 1765 d. 3 Aug 1846
Elkanah Benson
b. 21 Feb 1766 d. 8 Mar 1844
12
Samuel Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.6.3.7.1]
b. 21 May 1791 [
=>
]
12
Chloe Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.6.3.7.2]
b. 6 Jan 1793 d. 1882 [
=>
]
12
Adolphus Willard Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.6.3.7.3]
b. 17 Dec 1795 d. 18 May 1878 [
=>
]
12
Eliza Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.6.3.7.4]
b. 9 Mar 1798 d. 13 Nov 1817
12
Leonard Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.6.3.7.5]
b. 7 Apr 1800 d. 7 Sep 1877 [
=>
]
12
Phila Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.6.3.7.6]
b. 27 Jul 1802 [
=>
]
12
Calista Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.6.3.7.7]
b. 2 Jun 1804 d. 15 Sep 1882 [
=>
]
12
Ruth Wheelock Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.6.3.7.8]
b. 21 Sep 1807 [
=>
]
12
Sarah Elizabeth Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.6.3.7.9]
b. 1 Jul 1809 d. 20 Jul 1888 [
=>
]
10
Eleazar Wheelock
[1.1.6.1.1.1.1.1.6.4]
b. 31 Mar 1734 d. 31 Aug 1747
9
Rachel Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.7]
b. 1 Oct 1704 d. 1752
Uriah Thayer
b. 10 Sep 1706
10
Uriah Thayer
[1.1.6.1.1.1.1.1.7.1]
b. 16 Mar 1728 d. 1796
10
Ebenezer Thayer
[1.1.6.1.1.1.1.1.7.2]
b. 1731 d. 1775
10
Eleazer Thayer
[1.1.6.1.1.1.1.1.7.3]
b. 1733 d. 1755
10
Rachel Thayer
[1.1.6.1.1.1.1.1.7.4]
b. 19 Jun 1735 d. 1783
10
Martha Thayer
[1.1.6.1.1.1.1.1.7.5]
b. 1736 d. 1807
10
Simeon Thayer
[1.1.6.1.1.1.1.1.7.6]
b. 20 Oct 1739 d. 1764
9
Martha Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.8]
b. 15 Jun 1708 d. 6 Jan 1753
Joseph Benson
b. 14 Oct 1712 d. 24 Feb 1786
10
Moses Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.1]
b. 20 May 1732 d. 3 Jul 1806
Eunice Holbrook
b. 9 Aug 1735 d. Aft 1790
11
Aaron Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.1.1]
b. 28 Oct 1753 d. 8 Jul 1827
Lydia Fairbanks
b. 1758 d. 30 Aug 1814
12
Alanson Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.1.1.1]
b. 1783 d. 7 Dec 1857 [
=>
]
12
Polly Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.1.1.2]
b. 9 Apr 1785 d. 3 Dec 1847 [
=>
]
12
Aaron Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.1.1.3]
b. 10 Mar 1788
12
Ellis Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.1.1.4]
b. 13 Oct 1792 d. 31 Mar 1830
12
Lydia Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.1.1.5]
b. 15 Oct 1798 [
=>
]
11
David Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.1.2]
b. 23 Dec 1756 d. 8 Mar 1847
Zilla Marsh
b. 29 Aug 1760 d. 18 Jan 1817
12
Jessie Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.1.2.1]
b. 14 Mar 1781 d. Abt 1846 [
=>
]
12
Betsey Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.1.2.2]
b. 27 Jun 1782
12
Asenath Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.1.2.3]
b. 16 Feb 1784
12
Phineas Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.1.2.4]
b. 31 May 1785 d. 15 Mar 1835 [
=>
]
12
Levina Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.1.2.5]
b. 6 Sep 1786
12
Cyrus Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.1.2.6]
b. 23 Dec 1787
12
Matilda Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.1.2.7]
b. 10 Apr 1789
12
David Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.1.2.8]
b. 10 Apr 1789 d. 19 Oct 1868 [
=>
]
12
Moses Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.1.2.9]
b. 1 Oct 1792
12
Lewis Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.1.2.10]
b. 21 Jan 1794
12
Danford Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.1.2.11]
b. 1 Jul 1794 d. 14 Feb 1859 [
=>
]
12
Willard Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.1.2.12]
b. 7 Apr 1797
12
Susannah Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.1.2.13]
b. 7 Oct 1798 d. 4 Jan 1817
12
Hannah Azuba Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.1.2.14]
b. 4 Jul 1801
12
Albey Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.1.2.15]
b. 27 Aug 1804
11
Keziah Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.1.3]
b. 1 Mar 1759 d. Abt 1800
11
Daniel Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.1.4]
b. 1 Jun 1761 d. 9 Oct 1854
Phebe Bugbee
b. 1762 d. 3 May 1855
12
Annie Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.1.4.1]
b. 28 Mar 1787
12
Daniel Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.1.4.2]
b. 18 May 1788
12
John Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.1.4.3]
b. 19 Mar 1789
12
Mary Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.1.4.4]
b. 28 May 1791
12
Ebenezer Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.1.4.5]
b. 4 Sep 1793 d. 11 Mar 1870
12
Melinda Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.1.4.6]
b. 25 Jul 1795
12
Orrison Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.1.4.7]
b. 31 Aug 1797 d. 24 Apr 1883
12
Sally Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.1.4.8]
b. 30 Jul 1799 [
=>
]
12
Arza Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.1.4.9]
b. 7 Jul 1803
12
James Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.1.4.10]
b. 3 Jan 1805
12
Chester Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.1.4.11]
b. 26 Jan 1807 d. 19 Aug 1889 [
=>
]
12
Cynthia Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.1.4.12]
b. 16 Jan 1809
12
Fanny Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.1.4.13]
b. 2 Jun 1811
11
Peter Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.1.5]
b. 16 Jul 1763 d. 23 Mar 1854
11
Jesse Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.1.6]
b. 19 Feb 1766
11
Anna Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.1.7]
b. 6 Aug 1767
11
Hannah Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.1.8]
b. 3 Mar 1770
11
Susanna Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.1.9]
b. 26 Aug 1772
11
Eunice Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.1.10]
b. 4 May 1775
10
Joseph Benson, Jr
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.2]
b. 22 Oct 1735 d. 12 Jan 1818
10
Aaron Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.3]
b. 20 May 1738 d. 7 Nov
10
Benjamin Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.4]
b. 3 Mar 1742 d. 29 Mar 1802
Martha McNamara
b. 11 Mar 1745 d. 15 Sep 1806
11
Amasa Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.4.1]
b. 15 Mar 1770 d. 28 Oct 1777
11
Timothy Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.4.2]
b. 19 Aug 1771 d. 22 Oct 1777
11
Silence Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.4.3]
b. 30 Jul 1773 d. 10 Nov 1777
11
Hannah Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.4.4]
b. 18 Apr 1775 d. 22 Apr 1831
+
Asahel Pelton
b. 3 Aug 1773 d. 27 Mar 1857
11
Martha Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.4.5]
b. 26 Feb 1777
Timatha Gleason
b. 2 Aug 1779 d. 4 May 1841
12
Lucy Gleason
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.4.5.1]
b. 2 Feb 1804
12
Mary Gleason
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.4.5.2]
b. 23 Jul 1807
12
Fidelia Gleason
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.4.5.3]
b. 9 Jan 1811 d. Bef 1922
12
George G Gleason
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.4.5.4]
b. 27 Aug 1815
12
Martha Ann Gleason
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.4.5.5]
b. 16 Sep 1821
12
Martha Gleason
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.4.5.6]
b. 27 Sep 1822
11
Amasa Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.4.6]
b. 15 Feb 1779 d. 22 Feb 1847
11
Silence Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.4.7]
b. 8 Aug 1781 d. 4 Sep 1829
+
Clark Adams
b. 5 Nov 1773
11
Thankful Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.4.8]
b. 29 Aug 1783 d. 11 Apr 1808
Otis Taft
b. 17 Sep 1786 d. 19 Nov 1827
12
Tilus Vespasian Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.4.8.1]
b. 4 Jun 1806 d. 22 Feb 1889 [
=>
]
12
Benjamin B Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.4.8.2]
b. 28 Feb 1808
11
Benjamin Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.4.9]
b. 6 Jun 1786 d. 18 Mar 1815
11
Truelove Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.4.10]
b. 18 Nov 1788 d. 1 Aug 1837
+
Jonas Johnson
10
Abner Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.5]
b. Abt 1750
Experience Muxsom
b. 1753
11
Martha Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.5.1]
b. 27 Oct 1771 d. 7 Dec 1850
David Davis
b. 16 Oct 1767 d. 19 Nov 1811
12
Lucy Davis
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.5.1.1]
b. 14 Apr 1791 d. 1822 [
=>
]
12
David Davis
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.5.1.2]
b. 21 Dec 1792 [
=>
]
12
Hiram Davis
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.5.1.3]
b. Abt 1793 [
=>
]
12
Abner Davis
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.5.1.4]
b. 21 Sep 1795 d. 10 Dec 1874 [
=>
]
12
Suel Davis
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.5.1.5]
b. 13 Apr 1798 d. 28 Sep 1872 [
=>
]
11
Lucy Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.5.2]
b. 16 Apr 1774 d. 11 Dec 1815
11
Dennis Benson
[1.1.6.1.1.1.1.1.8.5.3]
b. 24 Jan 1777
9
Isaac Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.9]
b. 15 Jul 1710 d. 11 Oct 1776
Deborah White
b. 1711
10
Isaac Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.9.1]
b. 1743
10
Jonathan Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.9.2]
b. 5 Jan 1745 d. 1810
10
Artemas Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.9.3]
b. 28 Dec 1750 d. 1 Aug 1837
10
Susannah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.9.4]
b. 1753 d. 2 Apr 1819
10
Timothy Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.9.5]
b. 1757 d. 1824
10
Mary Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.9.6]
b. 1761
9
Thomas Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.10]
b. 5 Apr 1713 d. 25 Jan 1793
Lydia Thompson
b. 10 Dec 1710 d. Aft 1756
10
Thomas Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.10.1]
b. 14 May 1736 d. 15 May 1736
10
Kezia Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.10.2]
b. 7 May 1737 d. 3 Jul 1737
10
Lydia Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.10.3]
b. 18 May 1738 d. 29 Jan 1829
10
Charity Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.10.4]
b. 24 Nov 1742 d. 22 Aug 1747
10
Hannah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.10.5]
b. 6 Mar 1745
10
Nathaniel Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.10.6]
b. 15 Oct 1747 d. 12 Aug 1827
10
Amariah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.10.7]
b. 13 Feb 1750 d. 2 Mar 1750
10
Thomas Taft, Jr
[1.1.6.1.1.1.1.1.10.8]
b. 30 Oct 1753 d. 8 Jan 1835
Betsey Fletcher
b. 1772 d. 20 Sep 1819
11
Thomas Arnold Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.10.8.1]
b. 22 May 1794 d. 16 Apr 1871
Martha Willard Harrington
b. 16 Sep 1797 d. 10 Jan 1888
12
Betsey Willard Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.10.8.1.1]
b. 28 Nov 1815
12
Charlott Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.10.8.1.2]
b. 7 Jul 1817 d. 22 Feb 1883
12
Lewis Willard Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.10.8.1.3]
b. 19 May 1819
12
Arnold Austin Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.10.8.1.4]
b. 31 Dec 1820 d. 22 May 1853
12
George Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.10.8.1.5]
b. 10 Apr 1822 d. 7 Dec 1852
12
David Henry Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.10.8.1.6]
b. 31 Dec 1823
12
Martha Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.10.8.1.7]
b. 23 Feb 1826 d. 19 Feb 1903 [
=>
]
12
Stephen Claridon Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.10.8.1.8]
b. 30 Sep 1827 d. 23 Jan 1905
12
Charles Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.10.8.1.9]
b. 4 Oct 1829
12
Adin Ballou Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.10.8.1.10]
b. 7 Nov 1831
12
Waterman Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.10.8.1.11]
b. 13 Nov 1833
12
James Edward Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.10.8.1.12]
b. 4 Apr 1836
12
Jane Ellen Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.10.8.1.13]
b. 4 Apr 1836
12
Anna Sophia Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.10.8.1.14]
b. 7 Jul 1839
12
Julia August Freemon Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.10.8.1.15]
b. 29 Mar 1841 d. 15 Nov 1842
11
Stephen Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.10.8.2]
b. 30 Nov 1795
11
Thomas Taft, Jr
[1.1.6.1.1.1.1.1.10.8.3]
b. 26 Dec 1797 d. 24 Sep 1872
11
Betsey Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.10.8.4]
b. 7 Oct 1804
10
Genery Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.10.9]
b. 3 Jun 1756 d. 17 Aug 1761
9
Susanna Taft
[1.1.6.1.1.1.1.1.11]
b. 15 Mar 1714 d. 8 Nov 1751
John Fish
b. 30 Jun 1715 d. Aft 1772
10
Deborah Fish
[1.1.6.1.1.1.1.1.11.1]
b. 13 Feb 1741 d. 5 Mar 1826
10
Hannah Fish
[1.1.6.1.1.1.1.1.11.2]
b. 25 Jun 1744 d. 20 Sep 1836
10
Simeon Fish
[1.1.6.1.1.1.1.1.11.3]
b. 1747 d. 1825
10
Lydia Fish
[1.1.6.1.1.1.1.1.11.4]
b. 8 Sep 1749
10
John Fish
[1.1.6.1.1.1.1.1.11.5]
b. 7 Nov 1751 d. 7 Nov 1751
8
Robert Taft Jr
[1.1.6.1.1.1.1.2]
b. Abt 1674 d. 29 Apr 1748
Elizabeth Woodward
b. 15 Jun 1670 d. 7 Aug 1753
9
Robert Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.1]
b. 24 Dec 1697 d. 6 Mar 1776
Mary Chapin
b. 30 Apr 1700 d. 22 Jan 1768
10
Bethiah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.1.1]
b. 21 Dec 1721 d. 30 May 1741
10
Elizabeth Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.1.2]
b. 18 Jun 1723 d. 1779
10
Deborah Keith
[1.1.6.1.1.1.1.2.1.3]
b. 20 Feb 1728 d. 11 Apr 1806
10
Seth Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.1.4]
b. 27 Oct 1729 d. 15 Feb 1794
10
Jesse Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.1.5]
b. 4 Apr 1731 d. 1753
10
Abigail Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.1.6]
b. 20 Jan 1737
10
Ebenezer Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.1.7]
b. 8 Aug 1732 d. 3 Oct 1836
Polly Hayward
b. 10 Oct 1760 d. 15 Aug 1848
11
Enos Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.1.7.1]
b. 8 Dec 1779 d. 29 Dec 1812
11
Betsey Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.1.7.2]
b. 11 Jun 1781
11
Putman Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.1.7.3]
b. 5 Aug 1783 d. 20 Feb 1810
Abigail Benson
b. 13 Feb 1787
12
Mary Ann Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.1.7.3.1]
b. 23 Oct 1807
11
Polly Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.1.7.4]
b. 20 Jun 1785
11
Salley Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.1.7.5]
b. 21 Oct 1787 d. 7 Aug 1855
Jared Benson
b. 3 Feb 1785 d. 31 Jul 1854
12
James Sulliven Benson
[1.1.6.1.1.1.1.2.1.7.5.1]
b. 19 Sep 1808 d. 3 Jan 1833
12
Putman Taft Benson
[1.1.6.1.1.1.1.2.1.7.5.2]
b. 28 Oct 1814 d. 24 Apr 1834
12
Jared Benson
[1.1.6.1.1.1.1.2.1.7.5.3]
b. 8 Nov 1821 d. 18 May 1894 [
=>
]
12
Sylvanus Holbrook Benson
[1.1.6.1.1.1.1.2.1.7.5.4]
b. 23 Jun 1828 d. 1878 [
=>
]
11
Chloe Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.1.7.6]
b. 7 Nov 1789
11
Deborah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.1.7.7]
b. 21 Feb 1791 d. 14 Feb 1813
11
Leonard Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.1.7.8]
b. 17 Jun 1794 d. 25 Sep 1872
Martha Comstock
b. 17 Nov 1798 d. 14 May 1853
12
Hannah Mariah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.1.7.8.1]
b. 11 Jul 1824 d. 31 Jul 1844
12
Enos Nelson Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.1.7.8.2]
b. 12 Aug 1826
12
Leonard Almond Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.1.7.8.3]
b. 22 Jul 1828 d. 29 Jul 1857
12
Edward Henry Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.1.7.8.4]
b. 1 Jul 1830
11
Phila Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.1.7.9]
b. 25 Mar 1796 d. 26 Mar 1813
11
Ellis Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.1.7.10]
b. 23 May 1796 d. 27 Aug 1851
+
Aseneth Boyden
b. 10 Sep 1794 d. Apr 1886
11
Nancy Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.1.7.11]
b. 14 Aug 1801 d. 14 Jan 1849
9
Israel Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2]
b. 26 Apr 1699 d. 19 Sep 1753
Mercy Aldrich
b. 21 Jun 1700 d. Aft 19 Sep 1753
10
Huldah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1]
b. 28 Jun 1718 d. 2 Jul 1799
David Daniels
b. 4 Jul 1710 d. 21 May 1776
11
Ruth Daniels
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.1]
b. 13 Jul 1738 d. 26 Sep 1798
Jonathan Wheelock
b. 8 Sep 1731 d. 1774
12
Eleazer Wheelock
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.1.1]
b. 15 Jul 1756 d. 1841
12
Dole Wheelock
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.1.2]
b. 29 May 1758
12
Susannah Wheelock
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.1.3]
b. 23 Feb 1760 d. 2 May 1776
12
Lyman Wheelock
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.1.4]
b. 30 Nov 1761 d. 29 Mar 1848
12
Alphaeus Wheelock
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.1.5]
b. 17 Dec 1763
12
Willard Wheelock
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.1.6]
b. 19 Jun 1768 d. 29 Mar 1823
12
Deobrah Wheelock
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.1.7]
b. 17 Dec 1765 d. 3 Aug 1846 [
=>
]
Abraham Staples
b. 4 Apr 1731 d. 20 Oct 1803
12
Ruth Staples
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.1.8]
b. 22 Feb 1775 d. 10 Aug 1851 [
=>
]
12
Lendol Staples
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.1.9]
b. 1777
12
Susannah Staples
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.1.10]
b. 21 Jul 1780 d. 11 Feb 1818
11
Daniel Daniels
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.2]
b. 4 Nov 1740 d. 24 May 1832
Ruth Aldrich
b. 29 Jun 1741 d. 15 Jul 1801
12
Rachael Daniels
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.2.1]
b. 24 Dec 1767 d. 11 Aug 1846
12
Nathan Daniels
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.2.2]
b. 1769 d. 10 May 1839
12
Dianah Daniels
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.2.3]
b. 1774
12
Hulda Daniels
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.2.4]
b. 1776
12
Adolpheus Daniels
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.2.5]
b. 1778
12
Waite Daniels
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.2.6]
b. 1780
+
Nancy Thayer
b. Abt 1743 d. 10 Mar 1803
11
Molly Daniels
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.3]
b. 1 Oct 1741 d. 13 Apr 1793
Seth Kelley
b. 26 Nov 1730 d. 29 Apr 1799
12
Seth Kelley
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.3.1]
b. 10 Sep 1762 d. 27 Sep 1850
12
Mehitable Kelley
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.3.2]
b. 30 Apr 1765 d. 4 Nov 1798
12
Lettice Kelley
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.3.3]
b. 9 Jan 1768 d. 1 Feb 1843
12
Willis Kelley
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.3.4]
b. 14 Jan 1770 d. 23 Dec 1826
12
Moses Kelley
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.3.5]
b. 19 Oct 1771 d. 14 Sep 1776
12
Waite Kelley
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.3.6]
b. 12 Aug 1773 d. 7 Mar 1781
12
Asa Kelley
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.3.7]
b. 24 Mar 1775 d. 29 Apr 1852
12
John Kelley
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.3.8]
b. 12 Dec 1776 d. 17 Aug 1866
12
Daniel Kelley
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.3.9]
b. 23 Jul 1778 d. 23 Apr 1825
12
Mary Kelley
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.3.10]
b. 6 Jul 1780 d. 26 Feb 1802
12
Mark Kelley
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.3.11]
b. 1783 d. 12 Feb 1852
12
Hulda Kelley
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.3.12]
b. 1 Mar 1785 d. 29 Mar 1785
12
David Kelly
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.3.13]
b. 1786
11
Azor Daniels
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.4]
b. 20 Feb 1743 d. 19 Sep 1748
11
Chloe Daniels
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.5]
b. 13 Sep 1745 d. 19 May 1823
Seth Davenport
b. 2 Nov 1739 d. 28 Mar 1813
12
Anna Davenport
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.5.1]
b. 8 Sep 1765 d. 1 Aug 1842 [
=>
]
12
David Davenport
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.5.2]
b. 17 Jan 1767
12
Mary Davenport
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.5.3]
b. 30 Sep 1768
12
Rebecca Davenport
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.5.4]
b. 9 Apr 1770 d. 15 May 1794
12
Samuel Daniels Davenport
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.5.5]
b. 14 Oct 1772 d. 13 Feb 1802
12
Chloe Davenport
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.5.6]
b. 23 Mar 1774 d. 5 Mar 1808
12
Seth Davenport
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.5.7]
b. 13 Jan 1775 d. 22 Apr 1843
12
Benjamin Davenport
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.5.8]
b. 10 Jul 1780 d. 14 Jul 1862
11
Matilda Daniels
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.6]
b. 16 Sep 1747
John Gould
b. Abt 1758
12
Mary Gould
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.6.1]
b. 1779 d. 27 May 1854
11
David Daniels
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.7]
b. 10 Nov 1749 d. 30 Apr 1811
+
Olive Adams
b. 1 Jan 1755 d. 16 Sep 1832
11
Huldah Daniels
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.8]
b. 6 Jan 1752 d. 26 Jun 1836
Silas Penniman
b. 20 Aug 1751 d. 12 May 1777
12
Scammell Penniman
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.8.1]
b. 12 Oct 1772
12
Rhene Penniman
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.8.2]
b. 27 Jan 1774
12
Amos Penniman
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.8.3]
b. 9 Oct 1775
12
Silas Penniman
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.8.4]
b. 12 Aug 1777 d. 1820
Henry Dearth
b. 6 Jun 1741 d. 24 Jun 1804
12
Ruth Dearth
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.8.5]
b. 13 Jul 1787
12
Irene Dearth
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.8.6]
b. 7 Apr 1789
12
June Dearth
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.8.7]
b. 7 Apr 1789
12
Leonard Dearth
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.8.8]
b. 30 Oct 1791 d. 3 Feb 1880
12
Mercy Dearth
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.8.9]
b. 10 Sep 1793
11
Moses Daniels
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.9]
b. 25 Feb 1753
Abigail Aldrich
b. 25 Feb 1761 d. 5 Jul 1834
12
Cyrena Daniels
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.9.1]
b. 26 Sep 1782
12
Salley Daniels
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.9.2]
b. 27 Nov 1784 d. 6 Sep 1842
12
Abigail Daniels
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.9.3]
b. 15 Nov 1786
12
Elbridge C Daniels
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.9.4]
b. 28 Nov 1788
12
Kelly Daniels
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.9.5]
b. 23 Sep 1791 d. 30 Dec 1839
11
Clotilda Daniels
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.10]
b. 19 Sep 1755 d. Abt 1813
Sherebiah Baker
b. 18 Mar 1747 d. May 1823
12
Marshal Baker
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.10.1]
b. 8 Nov 1774 d. 20 Oct 1848
12
Phila Baker
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.10.2]
b. 10 Jul 1773
12
Marshall Baker
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.1.10.3]
b. 1779
10
Priscilla Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.2]
b. 15 Aug 1721 d. Jan 1760
Moses Wood
b. 3 Apr 1712 d. Apr 1780
11
Mary Wood
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.2.1]
b. 3 Mar 1740 d. 17 Apr 1841
11
Prissella Wood
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.2.2]
b. 18 May 1741 d. 18 May 1741
11
Jerusha Wood
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.2.3]
b. Abt 1744 d. 27 Apr 1790
11
Rachel Wood
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.2.4]
b. 9 Jun 1746
11
Moses Wood
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.2.5]
b. Abt 1748
11
Susanna Wood
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.2.6]
b. Abt 1748
11
Daniel Wood
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.2.7]
b. 10 Mar 1757
11
Hezekiah Wood
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.2.8]
b. 14 Jan 1760 d. 26 May 1811
11
Rhoda Wood
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.2.9]
b. 13 Apr 1762
10
Israel Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.3]
b. 23 Apr 1723 d. 1775
Martha Smith
b. 1722
11
Israel Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.3.1]
b. 12 Dec 1743
11
Amariah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.3.2]
b. 18 Apr 1746 d. 1770
11
Oliver Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.3.3]
b. 4 Feb 1750
11
Elizabeth Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.3.4]
b. 27 Jul 1753
11
Marce Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.3.5]
b. 16 Jan 1757
10
Jacob Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.4]
b. 22 Apr 1725 d. 15 Mar 1802
Esther Marsh
b. 28 Jun 1726 d. 14 Mar 1802
11
Esther Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.4.1]
b. 9 Jan 1747 d. 3 Feb 1834
James Taft
b. 9 Apr 1738 d. 14 Jan 1826
12
Lucy Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.4.1.1]
b. 22 Nov 1769 d. 29 Jul 1845 [
=>
]
12
Zilpha Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.4.1.2]
b. 1 Jul 1772 d. 24 Feb 1848 [
=>
]
12
Irena Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.4.1.3]
b. 25 Oct 1774 d. 29 May 1790
12
Ezekial Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.4.1.4]
b. 21 Jan 1777 d. 24 Apr 1841
12
James Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.4.1.5]
b. 13 Jun 1780
12
Luke Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.4.1.6]
b. 3 Jun 1783 [
=>
]
12
Esther Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.4.1.7]
b. 5 Aug 1786 d. 10 Aug 1858 [
=>
]
12
Moses Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.4.1.8]
b. 14 Jul 1788 d. 26 Jun 1810
12
Abigail Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.4.1.9]
b. 24 Jan 1791 d. 15 May 1837 [
=>
]
11
Timothy Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.4.2]
b. 3 Apr 1750 d. 30 Nov 1808
Priscilla Taft
b. 30 Apr 1749 d. 12 Sep 1833
12
Marcy Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.4.2.1]
b. 28 Sep 1771 d. 1 Aug 1848
12
Josiah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.4.2.2]
b. 3 May 1774
12
Abigail Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.4.2.3]
b. 14 Jan 1777 d. 17 Dec 1832 [
=>
]
12
Polly Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.4.2.4]
b. 1779 d. 5 Sep 1785
12
Timothy Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.4.2.5]
b. 1782 d. 5 Jan 1818 [
=>
]
12
Joseph Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.4.2.6]
b. 1784
12
Jonas Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.4.2.7]
b. 1786
12
Polly Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.4.2.8]
b. 1788 d. 1859
11
Jacob Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.4.3]
b. 1 Dec 1751 d. 30 May 1823
Mary Taft
b. 14 Feb 1753 d. 19 Jul 1832
12
Lois Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.4.3.1]
b. 27 Aug 1780 d. 27 Apr 1854 [
=>
]
12
Hannah Margaret Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.4.3.2]
b. 28 Nov 1782 d. 2 Apr 1857 [
=>
]
12
Elisabeth Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.4.3.3]
b. 8 Nov 1784 [
=>
]
12
Mary Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.4.3.4]
b. 16 Mar 1786 d. 25 Feb 1860
12
Charlotte Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.4.3.5]
b. 25 Feb 1789
12
John Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.4.3.6]
b. 3 Dec 1792 d. 29 May 1826 [
=>
]
12
Orsmus Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.4.3.7]
b. 1 Jan 1795
11
Abigail Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.4.4]
b. 5 Oct 1754 d. 12 Aug 1775
Barzillai Taft
b. 3 Nov 1750 d. 21 Jan 1839
12
Eunice Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.4.4.1]
b. 28 Jan 1775 d. 30 May 1861 [
=>
]
11
Lois Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.4.5]
b. 28 Apr 1757 d. 10 Feb 1792
Caleb Farnum
b. 9 Nov 1753 d. 3 Jan 1829
12
Royal Farnham
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.4.5.1]
b. 28 Nov 1775 d. 3 Sep 1845
12
Easman Farnum
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.4.5.2]
b. 22 Dec 1777 [
=>
]
12
Caleb Farnum
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.4.5.3]
b. 15 Jul 1781 d. 16 Jun 1863 [
=>
]
12
Clarissa Farnam
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.4.5.4]
b. 22 Aug 1784
11
Mercy Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.4.6]
b. 5 Mar 1758 d. 18 Feb 1843
Otis Russell
b. 9 Dec 1733
12
Meribah Russell
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.4.6.1]
b. 1805 d. Aft 1860
11
Israel Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.4.7]
b. 1 Mar 1761 d. 24 Apr 1842
Submit Read
b. 21 Jun 1763 d. 17 May 1841
12
Ruth Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.4.7.1]
b. 5 Jan 1783 [
=>
]
12
Clarisa Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.4.7.2]
b. 5 Mar 1786
12
Elzaphan Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.4.7.3]
b. 15 Feb 1788 d. 23 Mar 1847 [
=>
]
12
Abigail Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.4.7.4]
b. 9 Feb 1790 d. 5 Jun 1791
12
Laurana Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.4.7.5]
b. 13 May 1792 [
=>
]
12
Lydia Mariah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.4.7.6]
b. 10 Jul 1794 [
=>
]
12
Cyrus Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.4.7.7]
b. 3 Feb 1797 [
=>
]
12
Louis Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.4.7.8]
b. 25 Apr 1801
11
Eastman Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.4.8]
b. 16 Jun 1763 d. 29 Apr 1829
Chloa Taft
b. 25 Nov 1763 d. 4 May 1783
12
Eastman Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.4.8.1]
b. 2 May 1783 d. 8 Aug 1857
Hannah Taft
b. 1 Nov 1763 d. 3 Jul 1832
12
Chloe Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.4.8.2]
b. 7 Jul 1785 d. 25 Apr 1826 [
=>
]
12
Ezra Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.4.8.3]
b. 6 Mar 1793 d. 19 Feb 1808
10
Hannah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.5]
b. 16 Nov 1726 d. 15 Mar 1802
Elijah Clarke Benjamin
b. 8 Jun 1725 d. 1768
11
Elias Benjamin
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.5.1]
b. 4 May 1750 d. 8 Apr 1823
Rhoda Paddock
b. 9 Sep 1785 d. 5 Jun 1858
12
Deborah Benjamin
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.5.1.1]
b. 25 Apr 1803 d. 6 Dec 1871
12
Ezra H. Benjamin
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.5.1.2]
b. 21 May 1804 d. 20 Jul 1876
12
Edmund Benjamin
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.5.1.3]
b. 28 Jan 1806 d. 25 Nov 1887
12
Robert L Benjamin
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.5.1.4]
b. 14 Jun 1808 d. 20 Jul 1892
12
Hannah Almedia Benjamin
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.5.1.5]
b. 29 Sep 1810 d. Abt 1870
12
John Mills Benjamin
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.5.1.6]
b. 5 Jun 1813 d. 1849
12
Isaac Paddock Benjamin
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.5.1.7]
b. 21 Jul 1815 d. 5 Apr 1892
12
Mary E Benjamin
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.5.1.8]
b. 1 Sep 1817 d. 3 Dec 1819
12
William F Benjamin
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.5.1.9]
b. 18 Apr 1820 d. 10 Aug 1869
12
David E Benjamin
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.5.1.10]
b. 1 May 1822 d. 25 Aug 1890
12
Mary Elizabeth Benjamin
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.5.1.11]
b. 24 Jun 1824 d. 2 Oct 1894
12
Sidney S Benjamin
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.5.1.12]
b. 19 Jul 1826 d. 7 May 1862
12
Jane Ann Benjamin
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.5.1.13]
b. 7 Dec 1829 d. 29 Mar 1915
11
Chester Benjamin
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.5.2]
b. 9 Feb 1751 d. 1830
11
William Benjamin
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.5.3]
b. 6 Mar 1753
11
Captain Elijah Taft Benjamin
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.5.4]
b. 27 Dec 1755 d. 17 Jun 1819
Elizabeth Paddock
b. 1 Nov 1762 d. 26 Apr 1822
12
Elias Paddock Benjamin
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.5.4.1]
b. 6 May 1783 d. 27 Nov 1866
12
David Benjamin
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.5.4.2]
b. 18 May 1785 d. 18 Feb 1825
12
Elijah E Benjamin
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.5.4.3]
b. 26 Oct 1788 d. 19 May 1880
12
Charles Benjamin
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.5.4.4]
b. 7 Oct 1789 d. 10 Feb 1874
12
Daughter Benjamin
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.5.4.5]
b. 1791
12
Frederick B Benjamin
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.5.4.6]
b. 1794 d. 1868
12
Aaron Benjamin
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.5.4.7]
b. 1801 d. 4 Feb 1883
12
Loretta Benjamin
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.5.4.8]
b. 5 Feb 1804 d. 8 Feb 1886
11
Cyrus Benjamin
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.5.5]
b. 7 Jul 1762 d. 19 Jul 1817
Rhoda Maria Dibble
b. 7 Oct 1771 d. 8 Dec 1817
12
Mary Crosby Benjamin
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.5.5.1]
b. 11 Oct 1790
12
Hannah Benjamin
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.5.5.2]
b. 2 Jan 1792 d. 1 Jan 1794
12
David C Benjamin
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.5.5.3]
b. 7 Nov 1793
12
Anna Benjamin
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.5.5.4]
b. 22 Jan 1796 d. 9 Oct 1817
12
Annis Benjamin
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.5.5.5]
b. 10 Feb 1798 d. 16 Jun 1869
12
Peter Benjamin
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.5.5.6]
b. 14 Feb 1800 d. 2 Sep 1839
12
Cyrus Benjamin
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.5.5.7]
b. 11 Jul 1801
12
Nathaniel Benjamin
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.5.5.8]
b. 23 Jun 1803
12
Charles J Benjamin
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.5.5.9]
b. 17 Feb 1805 d. 1877
12
Elijah Benjamin
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.5.5.10]
b. 28 May 1807
12
Eliza "Wealthy" Benjamin
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.5.5.11]
b. 28 May 1807 d. 28 Jan 1862
12
Joel Samuel Benjamin
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.5.5.12]
b. 17 Apr 1809 d. 4 Feb 1882
12
Catherine E Benjamin
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.5.5.13]
b. 18 Jan 1814
12
Cyrus S Benjamin
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.5.5.14]
b. 13 Jun 1816
12
Daniel W Benjamin
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.5.5.15]
b. 13 Jun 1816 d. 2 Jun 1892
11
Hannah Benjamin
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.5.6]
b. 7 Jul 1762 d. 13 May 1840
11
Mary Benjamin
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.5.7]
b. 7 Jul 1768 d. 5 Feb 1849
11
Darius Benjamin
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.5.8]
b. 17 Jan 1758 d. 12 Feb 1850
10
Elisha Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.6]
b. 3 May 1728 d. 3 Mar 1791
Experience Taft
b. 7 Apr 1733 d. 15 Mar 1817
11
Hannah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.6.1]
b. 16 Mar 1758
11
Elisha Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.6.2]
b. 4 Mar 1761 d. 16 Jan 1820
Mary Sadler
b. 15 Aug 1768 d. 1800
12
Hiram Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.6.2.1]
b. 2 Apr 1789 d. 15 Nov 1794
12
Elisha Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.6.2.2]
b. 23 Jul 1791 d. 26 Feb 1858
12
Ormon Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.6.2.3]
b. 11 Nov 1793 d. 23 Jan 1794
12
Mary Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.6.2.4]
b. 23 May 1795 d. 23 Feb 1875
11
Sarah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.6.3]
b. 21 Mar 1763 d. 11 Oct 1835
Ezra Wood, Jr
b. 12 Mar 1759 d. 10 May 1837
12
Ezra Wood
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.6.3.1]
b. 25 Oct 1781
12
Experience Wood
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.6.3.2]
b. 16 Mar 1783 d. 14 Oct 1818
12
Sarah Wood
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.6.3.3]
b. 7 Aug 1784
12
Elisha Wood
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.6.3.4]
b. 24 Apr 1786 d. 19 Oct 1797
12
Jonathan Wood
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.6.3.5]
b. 8 Oct 1787 d. 26 Feb 1846
12
Anna Wood
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.6.3.6]
b. 31 Aug 1789 d. 20 Mar 1832
12
Chapin Wood
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.6.3.7]
b. 2 Apr 1792
12
Lucy Wood
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.6.3.8]
b. 11 Nov 1794 d. 10 Dec 1826
12
Silva Wood
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.6.3.9]
b. 29 Apr 1796
12
Silva Wood
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.6.3.10]
b. 29 Apr 1796
12
Phila Wood
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.6.3.11]
b. 5 Jul 1798
12
Elisha Wood
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.6.3.12]
b. 7 Nov 1800
12
Simeon Wood
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.6.3.13]
b. 5 Jan 1805
11
Israel Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.6.4]
b. 12 Feb 1766
11
Joseph Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.6.5]
b. 15 Sep 1768 d. Aft 29 Sep 1815
Sarah Farrar
b. 14 Sep 1764 d. 5 Aug 1810
12
Experience
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.6.5.1]
b. 5 Feb 1792
12
Amiel F Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.6.5.2]
b. 1 Oct 1794 d. 29 Nov 1869
12
Roxalana Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.6.5.3]
b. 22 Jan 1798
12
Sofrona Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.6.5.4]
b. 17 Jun 1800
12
Esquire Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.6.5.5]
b. 28 Apr 1803 d. 11 Mar 1865
12
Deborah R Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.6.5.6]
b. 6 Jan 1806
+
Marcy Stockwell
b. Abt 1794
10
Mercy Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.7]
b. 7 Apr 1733 d. 27 Mar 1801
Benjamin Green
b. 11 Aug 1734 d. 16 Aug 1797
11
Benjamin Green
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.7.1]
b. 6 Jan 1754
11
Israel Green
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.7.2]
b. 22 Jun 1755
11
Margery Green
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.7.3]
b. 1 Feb 1758 d. 22 Sep 1838
Josiah Taft
b. 28 Oct 1752 d. 8 Jan 1846
12
Josiah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.7.3.1]
b. 10 Apr 1778 d. 30 Dec 1790
12
Lydia Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.7.3.2]
b. 13 Feb 1780
12
Israel Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.7.3.3]
b. 30 Jul 1782 d. 10 Apr 1840 [
=>
]
12
Benjamin Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.7.3.4]
b. 3 Aug 1784 d. 13 May 1863
12
Mercy Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.7.3.5]
b. 1786 d. 12 Jun 1803
12
Polly Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.7.3.6]
b. 23 Sep 1790
12
Andre Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.7.3.7]
b. 25 Jun 1792 d. 26 Jun 1850 [
=>
]
12
Judson Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.7.3.8]
b. 14 Feb 1793 d. 26 Jan 1891
12
Eunice Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.7.3.9]
b. 14 Mar 1795
12
Harry Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.7.3.10]
b. 5 Mar 1797
12
Guilford Hodges Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.7.3.11]
b. 1 Jan 1799 d. 22 Nov 1816
11
Marcy Green
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.7.4]
b. 1 Jan 1760 d. 8 Jun 1815
Cummings Taft
b. 27 Aug 1770 d. 22 Jun 1841
12
Ezra Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.7.4.1]
b. 13 May 1797 d. 16 Nov 1878 [
=>
]
12
Benjamin Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.7.4.2]
b. 10 Aug 1798 d. 29 May 1799
12
Benjamin Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.7.4.3]
b. 6 May 1800 d. 17 Oct 1828 [
=>
]
12
Hannah G Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.7.4.4]
b. 18 May 1802 d. 8 Jan 1843 [
=>
]
11
Hannah Green
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.7.5]
b. 2 Apr 1763
11
Rachel Green
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.7.6]
b. 27 Aug 1765
11
Samuel Green
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.7.7]
b. 14 Mar 1767
10
Stephen Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.8]
b. 21 Aug 1734 d. 3 Feb 1803
Anna Taft
b. 14 Apr 1748 d. 3 Apr 1830
11
Lydia Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.8.1]
b. 13 Oct 1766 d. 13 Jan 1847
11
Hazeltine Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.8.2]
b. 6 Jan 1769 d. 18 Jul 1856
11
Gravenor Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.8.3]
b. 1773 d. 1838
11
Marcy Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.8.4]
b. 5 Sep 1775
11
Ephraim Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.8.5]
b. 18 Aug 1780
Elisabeth Taft
b. 8 Nov 1784
12
Mary Ann Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.8.5.1]
b. 22 May 1805
12
Ephriam Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.8.5.2]
b. 8 Feb 1807
11
Lovice Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.8.6]
b. 1 Jul 1783
11
Anna Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.8.7]
b. 29 Nov 1784
11
Stephen Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.8.8]
b. 12 Dec 1787
11
Adolphas Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.8.9]
b. 2 Oct 1791
10
Samuel Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.9]
b. 23 Sep 1735 d. 2 Aug 1816
Mary Murdock
b. 3 Jan 1742 d. 26 Mar 1785
11
Frederick Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.9.1]
b. 19 Jun 1759 d. 10 Feb 1846
Abigail Wood
b. 29 Aug 1761 d. 2 Jun 1851
12
Samuel Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.9.1.1]
b. 12 Dec 1782 d. 8 Feb 1842
12
Murdock Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.9.1.2]
b. 8 Dec 1784 d. 6 Aug 1820
12
Calista Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.9.1.3]
b. 31 Jan 1787 d. 11 Dec 1864
12
Clarinda Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.9.1.4]
b. 28 Feb 1789 d. 11 Apr 1877 [
=>
]
12
Frederic A Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.9.1.5]
b. 7 Apr 1790 d. 18 Sep 1837
12
Nabby Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.9.1.6]
b. 7 Jun 1793 d. 19 Jul 1880
12
Harriet Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.9.1.7]
b. 25 Jul 1795 d. 3 Sep 1852
12
Parla Parilla Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.9.1.8]
b. 5 Mar 1798 d. 26 Sep 1852
12
Ezra Wood Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.9.1.9]
b. 26 Aug 1800 d. 8 Feb 1885
12
Mary Ann Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.9.1.10]
b. 11 Sep 1803 d. 7 Sep 1850
12
Margaret Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.9.1.11]
b. 31 May 1806 d. 23 Jan 1891
11
Sibbel Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.9.2]
b. 19 Aug 1760 d. 28 Sep 1761
11
Lyman Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.9.3]
b. 14 Mar 1762 d. 24 Jul 1833
11
Mercy Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.9.4]
b. 23 Apr 1765 d. 25 Apr 1768
11
Willard Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.9.5]
b. 30 Oct 1766 d. 14 Sep 1845
11
Parley Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.9.6]
b. 20 Jan 1768 d. 13 Apr 1768
11
Merret Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.9.7]
b. 26 Jan 1769
11
Otis Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.9.8]
b. 29 Oct 1771
11
Farla Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.9.9]
b. 24 Mar 1774 d. 6 Apr 1864
11
Washington Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.9.10]
b. 16 Sep 1775
11
Philena Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.9.11]
b. 11 Mar 1781 d. 1814
11
George Washington Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.9.12]
b. 1 May 1783 d. 30 Nov 1824
Experiance Humes
b. 27 May 1750 d. 15 Jan 1837
11
Dandridge Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.9.13]
b. 1 Aug 1787 d. 10 Aug 1832
11
Warner Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.9.14]
b. 15 Sep 1789 d. 3 Aug 1837
11
Experiance Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.9.15]
b. 10 Jun 1791 d. 30 Nov 1863
11
Polley Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.9.16]
b. 18 Mar 1794
10
Margery Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.10]
b. 14 May 1738 d. 20 Jan 1813
Simeon Wood
b. 7 Jan 1732 d. 11 May 1802
11
Stephen Wood
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.10.1]
b. 14 Oct 1761 d. Abt 1820
11
Simeon Wood, Jr
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.10.2]
b. 14 Oct 1761 d. 1819
11
Rhoda Wood
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.10.3]
b. 25 May 1763 d. 8 Apr 1832
11
Jerusha Wood
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.10.4]
b. 28 Jun 1765 d. 8 Apr 1832
Asa Newell
b. 27 Nov 1761 d. 4 Aug 1808
12
Caleb Newell
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.10.4.1]
b. Abt 1786
12
Eabon Carter Newell
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.10.4.2]
b. 17 Nov 1788 d. 3 Mar 1831
12
Matilda Newell
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.10.4.3]
b. 1793 d. 28 Aug 1830
12
Lucretia Newell
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.10.4.4]
b. 24 Sep 1795 d. 29 Dec 1863 [
=>
]
12
Jerusha Newell
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.10.4.5]
b. 7 Nov 1799 d. 31 Oct 1879
12
Asa Newell
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.10.4.6]
b. 31 Aug 1803 d. Apr 1865
11
Caleb Wood
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.10.5]
b. 2 Jun 1767 d. 24 Jun 1769
11
Willis Wood
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.10.6]
b. 14 Jul 1769 d. 5 Oct 1779
11
Nathaniel G Wood
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.10.7]
b. 24 Jul 1771 d. 4 Sep 1847
11
Lois Wood
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.10.8]
b. 8 Nov 1772 d. 20 Apr 1773
11
Eunice Wood
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.10.9]
b. 11 Apr 1773 d. 28 Jun 1791
11
Jesse Wood
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.10.10]
b. 29 Aug 1775 d. Bef 1884
11
Mary Wood
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.10.11]
b. 3 Jan 1778 d. 3 Jan 1868
11
Sibel Wood
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.10.12]
b. 12 Jan 1781 d. Feb 1831
10
Silas Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.11]
b. 17 Dec 1739 d. 10 May 1741
10
Rachel Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.12]
b. 18 Jul 1742 d. 30 Dec 1747
10
Silas Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.13]
b. 5 Nov 1744
Elizabeth Sadler
b. 13 Sep 1754
11
Stephen Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.13.1]
b. 22 Feb 1773 d. 26 Oct 1846
11
Silas Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.13.2]
b. 2 Jun 1775
11
Israel Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.13.3]
b. 22 Sep 1777 d. 19 May 1842
11
Joel Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.13.4]
b. 28 Apr 1780
11
Belzaleel Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.13.5]
b. 28 Jan 1783 d. 15 Apr 1831
11
Otis Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.13.6]
b. 17 Sep 1786 d. 19 Nov 1827
Thankful Benson
b. 29 Aug 1783 d. 11 Apr 1808
12
Tilus Vespasian Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.13.6.1]
b. 4 Jun 1806 d. 22 Feb 1889 [
=>
]
12
Benjamin B Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.13.6.2]
b. 28 Feb 1808
11
Samuel Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.13.7]
b. 18 Oct 1788 d. 20 Oct 1859
11
Elisha Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.13.8]
b. 15 Feb 1791 d. 26 Dec 1849
11
Elizabeth Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.13.9]
b. 2 Feb 1795
10
Phila Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.2.14]
b. Abt 1748 d. 1794
9
Mary Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.3]
b. 21 Dec 1700 d. 1755
Benjamin Albee
b. 1 Nov 1694 d. 24 Jun 1755
10
Deacon Gideon Albee
[1.1.6.1.1.1.1.2.3.1]
b. 1 Mar 1723 d. 18 Oct 1799
10
Susanna Albee
[1.1.6.1.1.1.1.2.3.2]
b. Abt 1725 d. 8 Aug 1802
10
Jemima Albee
[1.1.6.1.1.1.1.2.3.3]
b. 7 Oct 1731 d. 7 Oct 1782
10
Peter Albee
[1.1.6.1.1.1.1.2.3.4]
b. 19 Jan 1736
10
Stephen Albee
[1.1.6.1.1.1.1.2.3.5]
b. Abt 1740
9
Elizabeth Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.4]
b. 18 Jun 1704 d. 1748
Peter Marvel
b. 1700 d. 26 Sep 1735
10
Margaret Marvel
[1.1.6.1.1.1.1.2.4.1]
b. Abt 1729
10
Tristan Marvel
[1.1.6.1.1.1.1.2.4.2]
b. Abt 1730 d. 29 Feb 1748
9
Alice Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.5]
b. 27 Jun 1707
+
Briggs
b. Abt 1700 d. Aft 1727
9
Eunice Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.6]
b. 20 Feb 1709 d. 27 Feb 1787
Obadiah Walker
b. 9 Oct 1691 d. 9 Jun 1760
10
Benjamin Walker
[1.1.6.1.1.1.1.2.6.1]
b. 30 Sep 1746 d. Bef 23 Nov 1813
9
John Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.7]
b. 18 Dec 1710 d. 19 Apr 1769
Hannah Cheney
b. 13 Feb 1711 d. 22 Feb 1759
10
Eunice Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.1]
b. 18 Jun 1735
Colonel Joseph Reed
b. 6 Mar 1731
11
Nathan Reed
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.1.1]
b. 9 Dec 1754
11
Eunice Reed
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.1.2]
b. 26 Dec 1755
11
Major Cheney Reed
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.1.3]
b. Abt 1759 d. 18 May 1822
11
Joseph Reed
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.1.4]
b. 1 Sep 1760
11
Hannah Reed
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.1.5]
b. 24 Jul 1762
10
Hannah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.2]
b. 4 Jul 1737 d. 2 Feb 1740
10
John Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.3]
b. 2 Jan 1740 d. 1 Feb 1808
Mary Harwood
b. 10 Jun 1745 d. 2 Jun 1782
11
Susanna Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.3.1]
b. 6 Mar 1763 d. 12 Feb 1846
11
Olive Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.3.2]
b. 11 Apr 1765
11
Margary Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.3.3]
b. 21 Aug 1767
11
Hulda Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.3.4]
b. 7 Apr 1770
10
Hannah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.4]
b. 5 Jun 1744
10
Bethiah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.5]
b. 9 Aug 1747
10
Robert Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.6]
b. 21 Jul 1749
Chloe Taft
b. 7 Jun 1753 d. 17 Oct 1843
11
Hannah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.6.1]
b. 21 Mar 1772 d. 3 Aug 1802
11
Josiah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.6.2]
b. 6 Jul 1776 d. 1845
11
Abigail Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.6.3]
b. 17 Aug 1778 d. 31 Oct 1850
11
Jesse Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.6.4]
b. 3 Feb 1781 d. 10 Jun 1783
11
Jesse Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.6.5]
b. 30 Apr 1782 d. 15 Oct 1869
11
Chloe Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.6.6]
b. 20 Jan 1786 d. 1809
11
Robert Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.6.7]
b. 26 Nov 1788 d. 16 Apr 1865
10
Josiah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.7]
b. 29 Nov 1752
10
Mary Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.8]
b. 14 Feb 1753 d. 19 Jul 1832
Jacob Taft
b. 1 Dec 1751 d. 30 May 1823
11
Lois Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.8.1]
b. 27 Aug 1780 d. 27 Apr 1854
Josiah Seagrave
b. 14 Oct 1773 d. 20 Mar 1855
12
Mary Ann Seagrave
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.8.1.1]
b. 17 Nov 1799 d. 10 Feb 1825
12
Jacob Taft Seagraves
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.8.1.2]
b. 8 Apr 1802 d. 24 Sep 1870
12
Henrietta Frost Seagrave
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.8.1.3]
b. 1 Dec 1803 d. 1 Jun 1823
12
Waity Grant Seagrave
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.8.1.4]
b. 23 Sep 1805 d. 27 Jan 1859
12
Edward Seagrave
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.8.1.5]
b. 3 Sep 1807 d. 15 Feb 1873
12
Lois Taft Seagrave
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.8.1.6]
b. 13 Apr 1809 d. 19 Mar 1853
12
Josiah Seagrave, Jr
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.8.1.7]
b. 24 May 1811 d. 21 Jul 1861
12
Malvina Seagrave
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.8.1.8]
b. 2 Apr 1813 d. 16 Dec 1823
12
Caleb Seagrave
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.8.1.9]
b. 8 Feb 1815 d. 14 Nov 1823
12
Son Seagrave
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.8.1.10]
b. 3 May 1817 d. 3 May 1817
12
Daughter Seagrave
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.8.1.11]
b. 3 May 1817 d. 3 May 1817
12
Esborn Seagrave
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.8.1.12]
b. 28 Dec 1818 d. 27 Oct 1856
12
George Augustus Seagrave
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.8.1.13]
b. 6 Jan 1823 d. 15 Nov 1884
11
Hannah Margaret Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.8.2]
b. 28 Nov 1782 d. 2 Apr 1857
Stephen Carpenter
b. 13 Aug 1778 d. 1 Oct 1854
12
Eunice Carpenter
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.8.2.1]
b. Sep 1802 d. Mar 1864
12
Orsmus T Carpenter
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.8.2.2]
b. Jan 1805 d. 4 Apr 1863
12
Joseph Rawson Carpenter
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.8.2.3]
b. 2 Apr 1807 d. May 1839
12
Charlotte Taft Carpenter
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.8.2.4]
b. 4 Feb 1809 d. 5 Sep 1845
12
Charles A Carpenter
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.8.2.5]
b. 11 Feb 1813 d. 12 Aug 1887
12
Mary T Carpenter
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.8.2.6]
b. 1815
12
Hannah Taft Carpenter
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.8.2.7]
b. 20 Aug 1817 d. 17 Dec 1890
12
Nancy Carter Carpenter
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.8.2.8]
b. 5 Jun 1820 d. 15 May 1898
12
Henrietta Carpenter
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.8.2.9]
b. Apr 1823 d. Feb 1847
12
George Carpenter
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.8.2.10]
b. 13 Jan 1825
11
Elisabeth Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.8.3]
b. 8 Nov 1784
Ephraim Taft
b. 18 Aug 1780
12
Mary Ann Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.8.3.1]
b. 22 May 1805
12
Ephriam Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.8.3.2]
b. 8 Feb 1807
11
Mary Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.8.4]
b. 16 Mar 1786 d. 25 Feb 1860
11
Charlotte Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.8.5]
b. 25 Feb 1789
11
John Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.8.6]
b. 3 Dec 1792 d. 29 May 1826
Lucretia Newell
b. 24 Sep 1795 d. 29 Dec 1863
12
Robert Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.8.6.1]
b. 27 May 1819
12
Jacob Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.8.6.2]
b. 19 May 1823
11
Orsmus Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.8.7]
b. 1 Jan 1795
Deborah White
b. 16 Feb 1722 d. 26 Oct 1806
10
Nathan Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.9]
b. 20 Oct 1766
10
Samuel Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.7.10]
b. 6 Feb 1769
9
Jemima Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.8]
b. 1 Apr 1713 d. 14 Oct 1787
Peter White
b. 6 Dec 1714 d. 8 May 1782
10
Joseph White
[1.1.6.1.1.1.1.2.8.1]
b. 25 Jun 1738 d. 1805
10
Bethaih White
[1.1.6.1.1.1.1.2.8.2]
b. 1 Mar 1740 d. 1809
10
Elisabeth White
[1.1.6.1.1.1.1.2.8.3]
b. 13 Dec 1743
10
Peter White
[1.1.6.1.1.1.1.2.8.4]
b. 1746 d. 2 Dec 1821
10
Jemima White
[1.1.6.1.1.1.1.2.8.5]
b. Abt 1754 d. Abt 1782
10
Nathan White
[1.1.6.1.1.1.1.2.8.6]
b. 10 Jan 1755 d. 21 Jan 1828
9
Gideon Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.9]
b. 4 Oct 1715 d. 1761
Elizabeth
b. Abt 1715
10
Nathan Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.9.1]
b. Abt 1735 d. 1 Dec 1741
10
Jemima Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.9.2]
b. 8 Sep 1736 d. 1 Aug 1742
10
Gideon Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.9.3]
b. 10 Nov 1738
10
Timothy Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.9.4]
b. 10 Sep 1740 d. 23 Nov 1741
10
Asa Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.9.5]
b. 8 May 1747 d. 10 Dec 1802
10
Elizabeth Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.9.6]
b. 1 Mar 1750
10
Phineas Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.9.7]
b. 29 Jan 1754 d. 6 Nov 1828
Jemima Thomson
b. 26 Jan 1752 d. 2 Dec 1837
11
Gideon Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.9.7.1]
b. 2 Mar 1776 d. 17 Nov 1859
11
David Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.9.7.2]
b. 1777 d. 1812
11
Mary Susan Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.9.7.3]
b. 1 Dec 1782 d. 28 Nov 1862
11
Cynthia Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.9.7.4]
b. Abt 1780 d. 8 Feb 1877
11
Otis Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.9.7.5]
b. 1785 d. 23 Apr 1855
11
Phineas Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.9.7.6]
b. 1790
11
Crispin Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.9.7.7]
b. 10 Feb 1793 d. 30 Jun 1862
10
Louise Taft
[1.1.6.1.1.1.1.2.9.8]
b. Jul 1756
8
Daniel Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3]
b. 1677 d. 24 Aug 1761
Lydia Chapin
b. 29 Sep 1677 d. 31 Mar 1758
9
Abigail Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.1]
b. 14 Sep 1707 d. 1736
Abraham Staples
b. 3 Apr 1706 d. Aug 1767
10
Debarah Staples
[1.1.6.1.1.1.1.3.1.1]
b. 16 Oct 1727
10
Abigail Staples
[1.1.6.1.1.1.1.3.1.2]
b. 12 Oct 1729 d. 31 Dec 1813
Benoni Benson
b. 18 Jul 1724 d. 10 Jan 1806
11
Henry Benson
[1.1.6.1.1.1.1.3.1.2.1]
b. Abt 1778
11
Joseph Benson
[1.1.6.1.1.1.1.3.1.2.2]
b. Abt 1784
10
Abraham Staples
[1.1.6.1.1.1.1.3.1.3]
b. 4 Apr 1731 d. 20 Oct 1803
Marcy Harvey
b. 1 Jun 1731 d. 1772
11
Jonathan Staples
[1.1.6.1.1.1.1.3.1.3.1]
b. 29 Mar 1754 d. 28 Nov 1832
Rachel Holbrook
b. 6 Nov 1753 d. 9 Mar 1832
12
Sally Staples
[1.1.6.1.1.1.1.3.1.3.1.1]
b. 3 Oct 1779
12
Sylvia Staples
[1.1.6.1.1.1.1.3.1.3.1.2]
b. 2 Jan 1781 d. 13 Mar 1852
12
Rachael Staples
[1.1.6.1.1.1.1.3.1.3.1.3]
b. Abt 1784 d. 12 Dec 1870
12
Ellery Staples
[1.1.6.1.1.1.1.3.1.3.1.4]
b. 1784 d. 1861
12
Willard Staples
[1.1.6.1.1.1.1.3.1.3.1.5]
b. 20 Dec 1785 d. 20 Dec 1858
12
Jonathan Staples
[1.1.6.1.1.1.1.3.1.3.1.6]
b. 1792
11
George Staples
[1.1.6.1.1.1.1.3.1.3.2]
b. 9 Mar 1756 d. 23 Sep 1820
11
Abagail Staples
[1.1.6.1.1.1.1.3.1.3.3]
b. 9 Aug 1758 d. 1825
11
Lydia Staples
[1.1.6.1.1.1.1.3.1.3.4]
b. 5 Feb 1761 d. 12 Dec 1818
11
Abraham Staples
[1.1.6.1.1.1.1.3.1.3.5]
b. 13 Aug 1766
11
Jacob Staples
[1.1.6.1.1.1.1.3.1.3.6]
b. 2 Oct 1768
11
Mary Staples
[1.1.6.1.1.1.1.3.1.3.7]
b. 10 Mar 1772
Ruth Daniels
b. 13 Jul 1738 d. 26 Sep 1798
11
Ruth Staples
[1.1.6.1.1.1.1.3.1.3.8]
b. 22 Feb 1775 d. 10 Aug 1851
Elias Thayer
b. 3 May 1773 d. 26 Jun 1833
12
Hannah Ellis Thayer
[1.1.6.1.1.1.1.3.1.3.8.1]
b. 19 Mar 1800 d. 26 Feb 1818 [
=>
]
12
Ruth Daniels Thayer
[1.1.6.1.1.1.1.3.1.3.8.2]
b. 16 Jul 1802
12
Mary Blake Thayer
[1.1.6.1.1.1.1.3.1.3.8.3]
b. 26 Nov 1804 d. 1870
12
Elias Thayer
[1.1.6.1.1.1.1.3.1.3.8.4]
b. 28 Oct 1806 d. 2 Nov 1808
12
Julia Ann Thayer
[1.1.6.1.1.1.1.3.1.3.8.5]
b. 13 Dec 1808 d. 6 Aug 1833
12
Lyman Wheelock Thayer
[1.1.6.1.1.1.1.3.1.3.8.6]
b. 6 May 1798 d. 5 Apr 1848
12
Susan Thayer
[1.1.6.1.1.1.1.3.1.3.8.7]
b. 1 Feb 1811 d. 7 Apr 1812
12
Elias Nelson Thayer
[1.1.6.1.1.1.1.3.1.3.8.8]
b. 3 Apr 1814 d. 6 Aug 1835
12
John Milton Thayer
[1.1.6.1.1.1.1.3.1.3.8.9]
b. 24 Jan 1820 d. 19 Mar 1906
11
Lendol Staples
[1.1.6.1.1.1.1.3.1.3.9]
b. 1777
11
Susannah Staples
[1.1.6.1.1.1.1.3.1.3.10]
b. 21 Jul 1780 d. 11 Feb 1818
10
Lydia Staples
[1.1.6.1.1.1.1.3.1.4]
b. 1746 d. Abt 1843
9
Josiah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.2]
b. 2 Apr 1709 d. 30 Sep 1756
Lydia Chapin
b. 2 Feb 1711 d. 9 Nov 1778
10
Josiah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.2.1]
b. 10 May 1733 d. 18 Aug 1761
10
Ebenezer Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.2.2]
b. 20 Aug 1735 d. 16 Oct 1735
10
Caleb Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.2.3]
b. 1738 d. 19 Sep 1756
10
Asahael Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.2.4]
b. 23 Apr 1740
10
Joel Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.2.5]
b. 15 Aug 1742 d. 23 Dec 1745
10
Joel Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.2.6]
b. 19 Feb 1747 d. 30 Aug 1749
10
Barzillai Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.2.7]
b. 3 Nov 1750 d. 21 Jan 1839
Abigail Taft
b. 5 Oct 1754 d. 12 Aug 1775
11
Eunice Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.2.7.1]
b. 28 Jan 1775 d. 30 May 1861
Phineas Chapin
b. 3 Aug 1769 d. 3 May 1839
12
Abby Chapin
[1.1.6.1.1.1.1.3.2.7.1.1]
b. 1 Feb 1796
12
Laurinda Chapin
[1.1.6.1.1.1.1.3.2.7.1.2]
b. 6 Feb 1798 d. 20 Dec 1866
12
Sarah Richardson Chapin
[1.1.6.1.1.1.1.3.2.7.1.3]
b. 30 Apr 1800 d. 16 Apr 1884
12
Chloe T Chapin
[1.1.6.1.1.1.1.3.2.7.1.4]
b. 8 Apr 1802 d. 5 Oct 1881
12
Mary Warren Chapin
[1.1.6.1.1.1.1.3.2.7.1.5]
b. 27 Feb 1804 d. 13 Nov 1890
12
Caleb Chapin
[1.1.6.1.1.1.1.3.2.7.1.6]
b. 6 Feb 1806 d. 27 Sep 1883 [
=>
]
12
Margaret Ann Chapin
[1.1.6.1.1.1.1.3.2.7.1.7]
b. 16 Jun 1808 d. 15 Nov 1897
12
Bezaileel Taft Chapin
[1.1.6.1.1.1.1.3.2.7.1.8]
b. 21 Oct 1810 d. 28 May 1855
12
Samuel Judson Chapin
[1.1.6.1.1.1.1.3.2.7.1.9]
b. 27 Aug 1812 d. 18 Nov 1908
12
Son Chapin
[1.1.6.1.1.1.1.3.2.7.1.10]
b. 15 Oct 1815
12
Gardner Spring Chapin
[1.1.6.1.1.1.1.3.2.7.1.11]
b. 2 Oct 1817 d. 4 Aug 1892
12
Josiah Spring Chapin
[1.1.6.1.1.1.1.3.2.7.1.12]
b. 24 Aug 1820 d. 26 Dec 1882
Sarah Richardson
b. 26 Sep 1756 d. 27 Apr 1809
11
Abigail Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.2.7.2]
b. 5 Dec 1777 d. 24 Sep 1778
11
Bezaleel Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.2.7.3]
b. 8 Sep 1780 d. 16 Jul 1846
11
Sally Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.2.7.4]
b. 2 Nov 1783 d. 12 Nov 1808
11
Caleb Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.2.7.5]
b. 20 Dec 1786 d. 3 Nov 1805
11
Chloe Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.2.7.6]
b. 10 Mar 1793 d. 3 Apr 1869
10
Chloe Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.2.8]
b. 7 Jun 1753 d. 17 Oct 1843
Robert Taft
b. 21 Jul 1749
11
Hannah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.2.8.1]
b. 21 Mar 1772 d. 3 Aug 1802
11
Josiah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.2.8.2]
b. 6 Jul 1776 d. 1845
11
Abigail Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.2.8.3]
b. 17 Aug 1778 d. 31 Oct 1850
11
Jesse Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.2.8.4]
b. 3 Feb 1781 d. 10 Jun 1783
11
Jesse Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.2.8.5]
b. 30 Apr 1782 d. 15 Oct 1869
11
Chloe Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.2.8.6]
b. 20 Jan 1786 d. 1809
11
Robert Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.2.8.7]
b. 26 Nov 1788 d. 16 Apr 1865
9
David Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.3]
b. 19 Apr 1711 d. 12 Oct 1756
Johanna Lovett
b. 12 May 1714 d. 25 Apr 1776
10
David Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.3.1]
b. 1736 d. 3 Sep 1769
10
Abigail Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.3.2]
b. 21 Jun 1739 d. Bef 1769
10
Phineas Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.3.3]
b. Abt 1741 d. 16 Jan 1745
10
Ephraim Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.3.4]
b. 14 Jul 1749
10
Joanna Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.3.5]
b. 14 Nov 1751 d. 3 Oct 1777
John Benson
b. 1 Aug 1749 d. 18 May 1818
11
Lovett Benson
[1.1.6.1.1.1.1.3.3.5.1]
b. 6 Oct 1772 d. 4 Mar 1773
11
Lois Benson
[1.1.6.1.1.1.1.3.3.5.2]
b. 17 Jul 1774 d. 10 Jul 1840
Manassah Baker
b. 4 Oct 1765 d. 30 Jun 1831
12
Sarah Williams Baker
[1.1.6.1.1.1.1.3.3.5.2.1]
b. 8 Feb 1796 [
=>
]
12
Sawyer Baker
[1.1.6.1.1.1.1.3.3.5.2.2]
b. 5 Nov 1797 d. 14 Oct 1802
12
Mary Sawyer Baker
[1.1.6.1.1.1.1.3.3.5.2.3]
b. 1 Apr 1800
12
Bezaleel Sawyer Baker
[1.1.6.1.1.1.1.3.3.5.2.4]
b. 13 Sep 1802
12
William Henry Baker
[1.1.6.1.1.1.1.3.3.5.2.5]
b. 8 Jun 1805
12
Chloe Taft Baker
[1.1.6.1.1.1.1.3.3.5.2.6]
b. 17 Dec 1807 [
=>
]
12
John William Baker
[1.1.6.1.1.1.1.3.3.5.2.7]
b. 29 Sep 1810
12
Hannah Dike Baker
[1.1.6.1.1.1.1.3.3.5.2.8]
b. 8 Nov 1813 d. 3 Jul 1836
12
John Brooks Baker
[1.1.6.1.1.1.1.3.3.5.2.9]
b. 30 Jul 1816
12
Caleb Strong Baker
[1.1.6.1.1.1.1.3.3.5.2.10]
b. 30 Jul 1816 d. 29 Dec 1834
11
Prudence Benson
[1.1.6.1.1.1.1.3.3.5.3]
b. 4 May 1776 d. 16 May 1789
10
James Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.3.6]
b. 25 Oct 1754 d. 14 Oct 1756
9
Lydia Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.4]
b. 13 Apr 1713 d. 17 Aug 1793
Charles Sheldon
b. Abt 1709 d. 20 Jul 1763
10
Timothy Sheldon
[1.1.6.1.1.1.1.3.4.1]
b. 17 Feb 1739 d. 1757
10
Lydia Sheldon
[1.1.6.1.1.1.1.3.4.2]
b. 1742 d. 1757
10
Daniel Sheldon
[1.1.6.1.1.1.1.3.4.3]
b. 8 Jan 1743 d. Feb 1821
10
Charles Sheldon
[1.1.6.1.1.1.1.3.4.4]
b. 26 Aug 1746 d. 14 Mar 1832
10
Hannah Sheldon
[1.1.6.1.1.1.1.3.4.5]
b. 10 Jul 1751 d. 11 Jun 1783
10
Ephraim Sheldon
[1.1.6.1.1.1.1.3.4.6]
b. 21 May 1754 d. 22 Apr 1840
9
Daniel Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.5]
b. 15 Apr 1715 d. 1761
Hopestill White
b. 15 Jul 1717
10
Mary Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.5.1]
b. Abt 1737 d. 24 Dec 1817
10
Comfort Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.5.2]
b. Abt 1739 d. 16 Mar 1824
10
Beulah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.5.3]
b. 10 Feb 1740 d. Dec 1828
10
Hephzibah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.5.4]
b. 10 Feb 1740 d. Bef 1749
10
Amos Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.5.5]
b. 25 Apr 1745 d. Sep 1767
10
Deborah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.5.6]
b. 6 Apr 1747
10
Hopestill Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.5.7]
b. 4 Jan 1749 d. Jun 1840
10
Daniel Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.5.8]
b. 22 Jul 1751 d. 12 May 1810
10
Jehoshaba Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.5.9]
b. 1755
10
Alpheus Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.5.10]
b. 11 Jan 1757
10
Zadoch Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.5.11]
b. 4 Feb 1759
10
Patience Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.5.12]
b. 16 Nov 1762 d. 12 May 1810
9
Japhet Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.6]
b. 24 Mar 1721 d. 24 Aug 1761
9
Caleb Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.7]
b. 1724 d. 1762
9
Ephraim Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.8]
b. 25 May 1718 d. 6 May 1748
Anna Read
b. 25 Oct 1728 d. 12 Mar 1797
10
Anna Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.8.1]
b. 14 Apr 1748 d. 3 Apr 1830
Stephen Taft
b. 21 Aug 1734 d. 3 Feb 1803
11
Lydia Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.8.1.1]
b. 13 Oct 1766 d. 13 Jan 1847
11
Hazeltine Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.8.1.2]
b. 6 Jan 1769 d. 18 Jul 1856
11
Gravenor Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.8.1.3]
b. 1773 d. 1838
11
Marcy Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.8.1.4]
b. 5 Sep 1775
11
Ephraim Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.8.1.5]
b. 18 Aug 1780
Elisabeth Taft
b. 8 Nov 1784
12
Mary Ann Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.8.1.5.1]
b. 22 May 1805
12
Ephriam Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.8.1.5.2]
b. 8 Feb 1807
11
Lovice Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.8.1.6]
b. 1 Jul 1783
11
Anna Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.8.1.7]
b. 29 Nov 1784
11
Stephen Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.8.1.8]
b. 12 Dec 1787
11
Adolphas Taft
[1.1.6.1.1.1.1.3.8.1.9]
b. 2 Oct 1791
8
Captain Joseph Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4]
b. 1680 d. 18 Jun 1747
Elizabeth Emerson
b. 6 Mar 1686 d. 18 Jun 1747
9
Lucy Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.1]
b. 22 Sep 1709
9
Lieutenant Moses Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2]
b. 30 Jan 1712 d. 16 Jul 1778
Priscilla Thayer
b. 6 Jun 1717 d. Aft 1761
10
Lieutenant Abner Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.1]
b. 28 Dec 1736 d. 30 May 1809
Tryal White
b. 8 May 1737 d. 14 Jun 1814
11
Oliver Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.1.1]
b. 1 May 1758 d. 16 Jul 1775
11
Moses Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.1.2]
b. 29 Sep 1760 d. 4 Dec 1848
Judith Cummings
b. 26 Nov 1766 d. 26 Nov 1816
12
Nancy Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.1.2.1]
b. 10 Mar 1787
12
Samuel Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.1.2.2]
b. 24 Sep 1790 d. 11 Oct 1863
12
Lucy Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.1.2.3]
b. 24 Apr 1795 d. 21 Jun 1847
12
Newell Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.1.2.4]
b. 28 Jul 1804 d. 4 Nov 1873 [
=>
]
12
Sylvia Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.1.2.5]
b. 23 Aug 1810 d. 3 Aug 1816
11
Mary Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.1.3]
b. 12 Oct 1767 d. 18 Aug 1775
11
Webb Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.1.4]
b. 26 Mar 1772 d. 21 Apr 1842
Lucy Taft
b. 9 Jun 1774 d. 14 Mar 1846
12
Lucinda Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.1.4.1]
b. 22 Nov 1793
12
Jason Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.1.4.2]
b. 5 Jun 1796 d. 25 Oct 1861
11
Trial T Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.1.5]
b. 13 Apr 1777 d. 18 Aug 1815
10
James Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.2]
b. 9 Apr 1738 d. 14 Jan 1826
Esther Taft
b. 9 Jan 1747 d. 3 Feb 1834
11
Lucy Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.2.1]
b. 22 Nov 1769 d. 29 Jul 1845
Ebenezer Winslow
b. 21 Jan 1772 d. 21 Feb 1841
12
Albert Winslow
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.2.1.1]
b. 24 Jul 1797 [
=>
]
12
Claramond Winslow
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.2.1.2]
b. 10 Feb 1799 d. 27 Apr 1834 [
=>
]
12
Alvin Winslow
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.2.1.3]
b. 27 Aug 1802 d. 9 Oct 1803
12
Paulina Maria Winslow
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.2.1.4]
b. 27 May 1805
12
Lucy Emma Winslow
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.2.1.5]
b. 17 Feb 1808 d. 20 Feb 1870
11
Zilpha Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.2.2]
b. 1 Jul 1772 d. 24 Feb 1848
Nathan Fisher
b. 25 Jun 1770 d. 21 Mar 1847
12
Elias Fisher
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.2.2.1]
b. 10 Jul 1796
12
Elise Fisher
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.2.2.2]
b. 10 Jul 1796
12
Josiah Fisher
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.2.2.3]
b. 26 Feb 1798 d. 11 Apr 1799
12
Josiah Fisher
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.2.2.4]
b. 1 Dec 1801
12
Rachel Adaline Fisher
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.2.2.5]
b. 29 Jan 1804
12
Mary Caroline Fisher
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.2.2.6]
b. 22 Mar 1806
12
Nathan Fisher
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.2.2.7]
b. 21 Mar 1811
11
Irena Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.2.3]
b. 25 Oct 1774 d. 29 May 1790
11
Ezekial Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.2.4]
b. 21 Jan 1777 d. 24 Apr 1841
+
Olive Thayer
b. 10 Aug 1782 d. 1865
11
James Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.2.5]
b. 13 Jun 1780
11
Luke Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.2.6]
b. 3 Jun 1783
Nancy Wood
b. 6 Feb 1787 d. 6 May 1859
12
Clarissa Wood Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.2.6.1]
b. 3 May 1810 d. 1889 [
=>
]
12
Moses Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.2.6.2]
b. 26 Jan 1812 [
=>
]
12
Sarah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.2.6.3]
b. 15 Jan 1815 d. 24 Dec 1898 [
=>
]
12
Irene Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.2.6.4]
b. 19 Sep 1816 d. 26 Jan 1900 [
=>
]
12
Chloe M Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.2.6.5]
b. 5 Feb 1823 [
=>
]
12
James Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.2.6.6]
b. 1830
11
Esther Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.2.7]
b. 5 Aug 1786 d. 10 Aug 1858
Fuller Murdock
b. 17 Feb 1781 d. 8 Nov 1857
12
Philena Murdock
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.2.7.1]
b. 26 Aug 1807 d. 30 Jun 1835 [
=>
]
12
Abba Eliza Murdock
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.2.7.2]
b. 13 Nov 1808 d. 4 Apr 1834 [
=>
]
12
Moses Taft Murdock
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.2.7.3]
b. 12 Sep 1810 d. 7 Feb 1883 [
=>
]
12
John Murdock
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.2.7.4]
b. 9 Sep 1812 d. 13 Sep 1837
12
Charles Murdock
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.2.7.5]
b. 11 Feb 1815 d. 6 Aug 1869 [
=>
]
12
Caleb Murdock
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.2.7.6]
b. 16 Feb 1817 d. 10 May 1892 [
=>
]
12
George Taft Murdock
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.2.7.7]
b. 18 Mar 1819 [
=>
]
12
Harriet E. Murdock
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.2.7.8]
b. 6 Feb 1821 d. 30 Nov 1904 [
=>
]
12
Chapin Murdock
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.2.7.9]
b. 20 Jun 1823 d. 17 Sep 1882 [
=>
]
12
Mary Ann Murdock
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.2.7.10]
b. 18 Jun 1825 d. 27 Aug 1834
11
Moses Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.2.8]
b. 14 Jul 1788 d. 26 Jun 1810
11
Abigail Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.2.9]
b. 24 Jan 1791 d. 15 May 1837
Chandler Taft
b. 29 May 1792
12
Augustine Calvin Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.2.9.1]
b. 11 May 1817 [
=>
]
10
Ruth Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.3]
b. 19 Feb 1740 d. 27 Jun 1797
10
Moses Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.4]
b. 21 Dec 1742
10
Margaret Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.5]
b. 19 Feb 1743 d. 3 Oct 1761
10
Nahum Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.6]
b. 17 Aug 1745
10
Priscilla Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.7]
b. 30 Apr 1749 d. 12 Sep 1833
Timothy Taft
b. 3 Apr 1750 d. 30 Nov 1808
11
Marcy Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.7.1]
b. 28 Sep 1771 d. 1 Aug 1848
+
Ezekiah Preston
b. Abt 1771
11
Josiah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.7.2]
b. 3 May 1774
11
Abigail Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.7.3]
b. 14 Jan 1777 d. 17 Dec 1832
Moses Stone
b. 2 Mar 1775 d. 10 May 1803
12
Jonas Stone
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.7.3.1]
b. 6 Jun 1795 d. 30 Sep 1795
12
Sukey Stone
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.7.3.2]
b. 19 Feb 1798
11
Polly Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.7.4]
b. 1779 d. 5 Sep 1785
11
Timothy Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.7.5]
b. 1782 d. 5 Jan 1818
Mary "Polly" Reidel
b. 8 Feb 1784 d. 8 Feb 1863
12
Timothy Clark Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.7.5.1]
b. 21 Jul 1800 d. 11 May 1872 [
=>
]
12
Adolphus Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.7.5.2]
b. Abt 1804
12
Harry Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.7.5.3]
b. Abt 1806
12
Ezekiel Preston Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.7.5.4]
b. Abt 1807
12
Washington Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.7.5.5]
b. Abt 1808 d. Abt 1823
12
Charlotte Clark Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.7.5.6]
b. Abt 1810
12
Christine Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.7.5.7]
b. 1811 d. 8 Jul 1847
12
Jacob R Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.7.5.8]
b. 29 Oct 1814 d. 1 Jan 1875
11
Joseph Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.7.6]
b. 1784
11
Jonas Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.7.7]
b. 1786
11
Polly Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.7.8]
b. 1788 d. 1859
10
Joseph Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.8]
b. 6 Jul 1751 d. 2 Jul 1828
Hannah Keith
b. 17 Jul 1753 d. 2 Apr 1842
11
Oliver Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.8.1]
b. 6 Nov 1771 d. 20 Feb 1853
Chloe
b. 1782 d. 24 Nov 1841
12
Olive Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.8.1.1]
b. 1 Mar 1806 d. 27 Jan 1867
12
Amariah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.8.1.2]
b. 19 Sep 1807 d. 28 Aug 1873 [
=>
]
12
Oliver Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.8.1.3]
b. 16 Jun 1812 d. 25 Mar 1876 [
=>
]
12
Maryan Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.8.1.4]
b. 9 Jul 1814 [
=>
]
12
George Washington Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.8.1.5]
b. 13 May 1823
Laura Ann M Taft
b. 26 Jun 1824 d. 26 May 1855
12
Laura Ann Maria Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.8.1.6]
b. 7 Jul 1844
12
Son Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.8.1.7]
b. 7 Jul 1844 d. 21 Jul 1844
12
Joseph K Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.8.1.8]
b. 25 Sep 1846 d. Jul 1868
12
Chloe Jane Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.8.1.9]
b. 25 Nov 1849
11
Huldah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.8.2]
b. 17 Feb 1775 d. Bef 21 May 1780
11
Huldah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.8.3]
b. 21 May 1780 d. 11 Oct 1811
Parker Tyler
b. 14 Nov 1790 d. 28 Jun 1853
12
Huldah Tyler
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.8.3.1]
b. 4 Oct 1811 [
=>
]
12
Hannah Tyler
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.8.3.2]
b. 4 Oct 1811 d. 18 Oct 1811
12
Martha Almira Tyler
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.8.3.3]
b. 28 Sep 1830 d. 16 Oct 1909 [
=>
]
11
Hannah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.8.4]
b. 29 Sep 1783
11
Peter Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.8.5]
b. 24 Apr 1786
10
Luke Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.9]
b. 10 Aug 1754
10
Joanna Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.10]
b. 26 Jun 1756 d. 30 Sep 1761
10
Josiah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.2.11]
b. 1 Oct 1758 d. 29 Sep 1761
9
Peter Rawson Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3]
b. 1715 d. 12 Dec 1783
Elizabeth Cheney
b. 21 Sep 1707 d. 21 Sep 1783
10
Henry Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.1]
b. 7 Feb 1737 d. 2 Feb 1812
Sarah Howe
b. 14 Apr 1742 d. 26 Jun 1789
11
Joel Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.1.1]
b. 7 Nov 1763 d. 10 Oct 1855
Polly Earle
b. 28 Mar 1774 d. 1864
12
Martha Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.1.1.1]
b. 24 Dec 1802 d. Bef 1860
12
Emons Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.1.1.2]
b. 7 Apr 1804
12
Lewis Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.1.1.3]
b. 1814 d. Bef 1860 [
=>
]
12
Rufus Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.1.1.4]
b. 18 Mar 1817 d. Bef 1860
12
Roxana Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.1.1.5]
b. 14 Dec 1819 d. Bef 1860
11
Peter Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.1.2]
b. 11 Jan 1773
Phebe Wheaton
b. 28 May 1771
12
Phebe Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.1.2.1]
b. 15 Jan 1809 d. 12 Mar 1849 [
=>
]
11
Lydia Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.1.3]
b. 15 Oct 1766 d. 28 Jul 1786
11
Amos Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.1.4]
b. 26 Aug 1768 d. 6 Aug 1789
11
Sarah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.1.5]
b. 18 Jan 1771 d. 22 Feb 1792
11
Caleb Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.1.6]
b. 2 Apr 1775 d. 26 Oct 1840
Lois Carleton
b. Abt 1776
12
Lois Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.1.6.1]
b. 10 Mar 1801
12
Rhoda Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.1.6.2]
b. 20 Oct 1802
12
Calvin Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.1.6.3]
b. 11 Dec 1804
12
Lydia Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.1.6.4]
b. 30 Apr 1806
12
Nancy Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.1.6.5]
b. 19 Sep 1809
12
Dudley Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.1.6.6]
b. 6 Nov 1811 [
=>
]
12
Daniel Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.1.6.7]
b. 21 Dec 1815
11
Abisha Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.1.7]
b. 15 Jun 1777
Mary Bliss
d. 1 Feb 1822
12
Tryphina Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.1.7.1]
b. 29 Jun 1810 d. 13 Oct 1849
12
Clarissa Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.1.7.2]
b. 1817 d. 24 Dec 1840
12
Denison Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.1.7.3]
b. 6 Jun 1819 [
=>
]
+
Sally Sprague
11
David Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.1.8]
b. 13 Aug 1779
10
Gershom Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.2]
b. 20 Oct 1739 d. 29 Apr 1813
Abigail Reed
b. 12 Dec 1736 d. 24 Feb 1816
11
Calvin Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.2.1]
b. 17 Nov 1765 d. 12 Feb 1816
Molley
b. 1755 d. 12 Feb 1847
12
Newell Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.2.1.1]
b. 13 Feb 1788
12
Benjamin Clark Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.2.1.2]
b. 17 May 1790
12
Chandler Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.2.1.3]
b. 29 May 1792 [
=>
]
12
Ohila Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.2.1.4]
b. 25 Mar 1796
12
Mellen Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.2.1.5]
b. 18 Oct 1799 d. 3 Jun 1839
12
Mary Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.2.1.6]
b. 25 Aug 1803 d. 20 Feb 1816
12
Eliza Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.2.1.7]
b. 20 Jun 1805
12
James Whitman Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.2.1.8]
b. 21 Jan 1809 d. 8 Aug 1834
11
Elisabeth Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.2.2]
b. 13 May 1769 d. Bef 1871
11
Cheney Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.2.3]
b. 3 May 1771 d. 27 Jun 1838
11
Ruth Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.2.4]
b. 23 Feb 1773
11
Phila Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.2.5]
b. 4 Jul 1775 d. 29 Sep 1776
11
Reed Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.2.6]
b. 13 Mar 1780
10
Peter Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.3]
b. 26 Aug 1741 d. 13 Sep 1802
+
Mercy Corpe
b. 11 Dec 1732
10
Aaron Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.4]
b. 28 May 1743 d. 26 Mar 1808
Rhoda Rawson
b. 4 Oct 1749 d. 9 Jun 1827
11
Millie Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.4.1]
b. 29 Jul 1769
Ezekiel Clark
b. 13 Apr 1766
12
Willard Boyd Clark
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.4.1.1]
b. 18 May 1792
12
William B Clark
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.4.1.2]
b. 15 Apr 1793 d. 27 Apr 1818
12
Lucis Clark
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.4.1.3]
b. 4 Sep 1795
12
Lewis C Clark
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.4.1.4]
b. 6 Sep 1795 d. 16 Jan 1831
12
Maria Clark
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.4.1.5]
b. 12 Jul 1798
12
Franklin Clark
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.4.1.6]
b. 13 Dec 1801 d. 1 Feb 1846
12
Charles T Clark
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.4.1.7]
b. 8 Apr 1804
11
Selina Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.4.2]
b. 20 Feb 1771 d. 22 Sep 1838
Jesse Ensign Murdock
b. 13 Sep 1762 d. 11 May 1850
12
Judson Murdock
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.4.2.1]
b. 24 Aug 1794 d. 26 Jun 1877 [
=>
]
12
Harriet Fuller Murdock
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.4.2.2]
b. 17 Nov 1798 d. 5 May 1838 [
=>
]
12
Selina Fuller Murdock
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.4.2.3]
b. 24 Dec 1803 d. 19 Apr 1860 [
=>
]
12
Eliza Taft Murdock
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.4.2.4]
b. 8 Mar 1808 d. Bef 1812
12
Eliza Murdock
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.4.2.5]
b. 31 Jul 1812
11
Cynthia Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.4.3]
b. 17 Aug 1773
Nathaniel Butler
b. 1769
12
Cynthia M Butler
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.4.3.1]
b. 12 Aug 1802 d. 24 Jan 1875
12
George T Butler
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.4.3.2]
b. 24 Nov 1804 d. 5 Nov 1841 [
=>
]
12
Rawson A Butler
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.4.3.3]
b. 8 Jun 1806 d. 9 Sep 1865 [
=>
]
12
Marian Butler
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.4.3.4]
b. 19 Mar 1809 [
=>
]
11
Polly Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.4.4]
b. 18 Sep 1777 d. 29 Aug 1816
Hezediah Murdock
b. 30 Jun 1776 d. 17 Aug 1864
12
Bazaleel White Murdock
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.4.4.1]
b. 22 Nov 1798 d. 6 Aug 1809
12
Polly Taft Murdock
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.4.4.2]
b. 28 Mar 1803 d. 26 Nov 1846 [
=>
]
12
Stephen Murdock
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.4.4.3]
b. 4 Mar 1801 d. 29 Dec 1889 [
=>
]
12
Levi Murdock
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.4.4.4]
b. Abt 1802
12
John Murdock
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.4.4.5]
b. 2 Nov 1806 d. 8 Dec 1891 [
=>
]
12
Sylvia Murdock
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.4.4.6]
b. 28 Feb 1808 d. 23 Dec 1885 [
=>
]
12
Grosvenor Taft Murdock
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.4.4.7]
b. 29 May 1814 d. 23 Dec 1891
12
Son Murdock
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.4.4.8]
b. 1816 d. 25 May 1816
12
Benjamin Read Murdock
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.4.4.9]
b. 20 Aug 1817 d. 20 Oct 1842 [
=>
]
12
Sophia Murdock
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.4.4.10]
b. 31 Aug 1819 d. 21 Oct 1889 [
=>
]
11
Zeruiah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.4.5]
b. 21 Nov 1779 d. 21 Oct 1852
Major Willard Lovell
b. 1782 d. 1839
12
Lucia Lovell
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.4.5.1]
b. 19 May 1808
12
Mary Malgretta Lovell
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.4.5.2]
b. 6 Dec 1809 d. 1857 [
=>
]
12
Cynthia Ann Lovell
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.4.5.3]
b. 29 Apr 1811 d. Bef 1861
12
Elizabeth Adeline Lovell
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.4.5.4]
b. 4 Mar 1815 d. 29 Aug 1818
12
George Lovell
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.4.5.5]
b. 9 Dec 1818
12
Enos Lovell
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.4.5.6]
b. 22 Jul 1821 d. 16 Sep 1821
12
Lafayette Lovell
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.4.5.7]
b. 27 May 1823
11
Mary Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.4.6]
b. 12 Jul 1783 d. 7 Feb 1839
+
Nathaniel Stiles
b. 22 Jun 1777 d. 1829
11
Peter Rawson Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.4.7]
b. 14 Apr 1785 d. 1 Jan 1867
Sylvia Howard
b. 1 Feb 1792 d. 1886
12
Alphonso Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.4.7.1]
b. 5 Nov 1810 d. 21 May 1891 [
=>
]
11
Sophia Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.4.8]
b. 30 Dec 1787 d. 27 Nov 1843
11
Samuel Judson Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.4.9]
b. 6 Nov 1791 d. 9 Jun 1867
Lucy C Hayward
b. 1795 d. 21 Dec 1862
12
Sophia Amelia Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.4.9.1]
d. 12 Dec 1900 [
=>
]
10
Thankful Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.5]
b. 25 May 1745 d. 26 Oct 1837
Stephen Sibley
b. 12 Jul 1741 d. 25 Aug 1828
11
Joel Sibley
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.5.1]
b. 25 Apr 1766 d. 10 Apr 1839
Lois Louise Woods
b. 24 Jun 1767 d. 21 Nov 1832
12
Amory Sibley
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.5.1.1]
b. 20 Jun 1792 d. 22 Jun 1849 [
=>
]
12
Josiah Sibley
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.5.1.2]
b. 1 Apr 1808 d. 7 Dec 1888 [
=>
]
11
Lydia Sibley
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.5.2]
b. 2 Apr 1769 d. 27 Nov 1822
Henry Staples Benson
b. 8 Aug 1770 d. 29 Jul 1821
12
Abigail Benson
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.5.2.1]
b. 31 Mar 1795 d. 10 Nov 1821 [
=>
]
12
Harriet Benson
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.5.2.2]
b. 14 Sep 1796 d. 22 Aug 1852
12
Mellen Benson
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.5.2.3]
b. 14 Jan 1798 [
=>
]
12
Hannah Adaline Benson
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.5.2.4]
b. 12 Aug 1802 d. 19 Jun 1822
12
Rufus Benson
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.5.2.5]
b. 24 Jan 1804 d. 23 Aug 1805
12
Chloe Ann Benson
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.5.2.6]
b. 23 Aug 1806
12
Susan Augusta Benson
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.5.2.7]
b. 9 Oct 1809 d. 25 Jul 1831 [
=>
]
12
Rufus Aldrich Benson
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.5.2.8]
b. 9 Oct 1809
12
Stephen Sibley Benson
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.5.2.9]
b. 9 Jan 1810 d. 20 Nov 1869 [
=>
]
10
Joel Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.3.6]
b. 28 May 1747 d. 27 Sep 1758
9
Sarah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.4]
b. 9 Mar 1719
9
Captain Joseph Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.5]
b. 19 Apr 1722 d. 25 Dec 1787
Elizabeth Thayer
b. 13 Feb 1724 d. 27 Aug 1797
10
Rueben Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.1]
b. 21 Oct 1742 d. Aft 1761
Faithful Thayer
b. 18 Jun 1744 d. 1827
11
Susannah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.1.1]
b. 27 Dec 1761 d. 14 Nov 1825
Isaac Dresser
b. 22 Feb 1759 d. 4 Dec 1835
12
Reuben Dresser
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.1.1.1]
b. 11 Jun 1781 d. 5 Sep 1782
12
Betsey Dresser
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.1.1.2]
b. 22 May 1783
12
Polly Dresser
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.1.1.3]
b. 14 Jun 1785
12
Leonard Dresser
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.1.1.4]
b. 7 Aug 1787 d. 26 Apr 1838 [
=>
]
12
Clarissa Dresser
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.1.1.5]
b. 4 Sep 1789 d. 5 Aug 1867 [
=>
]
12
Susanna Dresser
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.1.1.6]
b. 3 Nov 1791
12
Isaac Dresser
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.1.1.7]
b. 19 May 1793 d. 5 Feb 1862 [
=>
]
12
Diana Dresser
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.1.1.8]
b. 17 Dec 1795
12
David Dresser
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.1.1.9]
b. 12 Sep 1797 [
=>
]
11
Nancy Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.1.2]
b. 9 Jul 1763 d. 1835
11
Rhoxanna Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.1.3]
b. 14 Aug 1765 d. 1837
+
Josiah Wood
11
Diana Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.1.4]
b. 4 Sep 1767 d. 1830
+
Silvanus Thayer
b. 4 Sep 1762
11
Joseph Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.1.5]
b. 26 Jun 1769
11
Marcy Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.1.6]
b. 11 Aug 1771 d. 1840
11
Polly Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.1.7]
b. 9 Jun 1773 d. 26 Oct 1848
Jesse Hurlbut
b. 21 Jul 1769 d. 11 Jan 1848
12
Polly Hurlbut
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.1.7.1]
b. 27 Apr 1793 d. 17 Sep 1861 [
=>
]
12
Reuben Hurlbut
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.1.7.2]
b. 7 Apr 1794 d. 28 May 1879 [
=>
]
12
Aseneth Hurlbut
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.1.7.3]
b. 7 Jan 1797 d. 26 May 1875 [
=>
]
12
Diana Hurlbut
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.1.7.4]
b. 29 Mar 1798 d. 1 Mar 1841
12
Alma Hurlbut
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.1.7.5]
b. 13 Feb 1800
12
Hiram Higgins Hurlbut
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.1.7.6]
b. 29 Nov 1801 d. 20 Jul 1864 [
=>
]
12
Horatio Hurlbut
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.1.7.7]
b. 9 Nov 1806 d. 1890 [
=>
]
12
Quartus Ovando Hurlbut
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.1.7.8]
b. 7 Feb 1804 d. 10 Jan 1879
11
Ruth Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.1.8]
b. 5 Jul 1778 d. 1860
William Smith
b. Abt 1779
12
Thomas Smith
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.1.8.1]
b. Abt 1803 d. 21 Feb 1884
11
Betsy Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.1.9]
b. 24 Mar 1776 d. Feb 1853
Moses Chapin
b. 24 May 1776 d. 19 Jul 1844
12
Joseph Chapin
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.1.9.1]
b. 15 Jul 1797 d. 12 Jun 1857 [
=>
]
12
Stephen Chapin
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.1.9.2]
b. 4 Jan 1801 d. 9 Mar 1843 [
=>
]
12
Ruth Adaline Chapin
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.1.9.3]
b. 24 Oct 1802 d. 1862 [
=>
]
12
Orris Taft Chapin
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.1.9.4]
b. 27 Jan 1805 d. 20 Dec 1849 [
=>
]
12
Betsy Taft Chapin
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.1.9.5]
b. 14 Oct 1807 d. 21 Apr 1838 [
=>
]
12
Abigail Adams Chapin
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.1.9.6]
b. 4 Sep 1809 d. 6 Aug 1854 [
=>
]
12
Diana Maria Chapin
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.1.9.7]
b. 9 Mar 1812 d. 23 Aug 1854 [
=>
]
12
Moses Smeadley Chapin
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.1.9.8]
b. 15 Aug 1816 d. 14 Nov 1819
12
Adaline Chapin
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.1.9.9]
b. 14 May 1820 d. 1904
10
Lucy Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.2]
b. 5 Mar 1745 d. 1822
10
Silas Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.3]
b. 22 Nov 1747
10
Sarah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.4]
b. 8 Mar 1750 d. 3 May 1811
10
Asahel Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.5]
b. 30 Jul 1752 d. Nov 1826
Rachel Alton
b. 9 Mar 1760 d. 5 Aug 1851
11
Silas Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.5.1]
b. 21 Oct 1780
11
Elizabeth Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.5.2]
b. 17 Mar 1783
11
Rachel Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.5.3]
b. Abt 1785
11
Mary Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.5.4]
b. 1787
11
Asahel J Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.5.5]
b. 1792
11
Joseph Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.5.6]
b. 15 Jun 1794
11
Sarah Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.5.7]
b. 28 Feb 1797 d. 29 Sep 1879
Wheaton W Wilson
b. 5 Aug 1787 d. 13 Jan 1874
12
Wheaton Wilson
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.5.7.1]
b. 10 Nov 1817 d. 17 Aug 1900
12
Mary Wilson
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.5.7.2]
b. 7 Sep 1820 d. 23 Nov 1887
12
Fanny Maria Wilson
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.5.7.3]
b. 12 Sep 1822 d. 1900
12
Alonzo Wilson
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.5.7.4]
b. 19 Sep 1824 d. 13 Oct 1826
12
Emily Wilson
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.5.7.5]
b. 7 May 1827
12
Sophia Wilson
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.5.7.6]
b. 19 Jul 1829 d. 9 Apr 1919
12
Caroline Louisa Wilson
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.5.7.7]
b. 4 Mar 1832 d. 11 Mar 1892
12
John Wilson
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.5.7.8]
b. 26 May 1834
12
William Walter Wilson
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.5.7.9]
b. 8 Sep 1836 d. 31 Jul 1839
12
Wallace Warren Wilson
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.5.7.10]
b. 28 Sep 1839 d. 22 Oct 1906 [
=>
]
11
Fannie Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.5.8]
b. 14 Jan 1801 d. 3 Sep 1867
11
Emily Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.5.9]
b. 8 Mar 1803
10
Ezra Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.6]
b. 22 Dec 1752 d. Aft 1803
10
Ruth Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.5.7]
b. 13 May 1763
9
Elizabeth Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.6]
b. 30 Oct 1724
Jonathan Penniman
b. 30 Jul 1719 d. 18 Jul 1747
10
Jonathan Peniman
[1.1.6.1.1.1.1.4.6.1]
b. 21 Mar 1744 d. 2 Sep 1761
10
Mary Peniman
[1.1.6.1.1.1.1.4.6.2]
b. 27 Oct 1746 d. 5 Jul 1749
10
Ann Peniman
[1.1.6.1.1.1.1.4.6.3]
b. 26 Aug 1749
10
Adna Penniman
[1.1.6.1.1.1.1.4.6.4]
b. 5 Oct 1752 d. 4 Nov 1820
10
Bethiah Peniman
[1.1.6.1.1.1.1.4.6.5]
b. 12 Nov 1758
10
Nathan Peniman
[1.1.6.1.1.1.1.4.6.6]
b. 26 Nov 1766 d. 11 Jun 1831
9
Aaron Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.7]
b. 12 Apr 1727 d. 5 Nov 1805
Marcy Arnold
b. 24 Jan 1733 d. 22 Jan 1806
10
Rhoda Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.7.1]
b. 4 Feb 1753 d. 4 Apr 1837
10
Arnold Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.7.2]
b. 4 May 1756
10
Thaddeus Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.7.3]
b. 13 Dec 1757 d. 5 Sep 1831
10
Patiance Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.7.4]
b. 1 Sep 1761 d. 26 Nov 1816
10
Zadock Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.7.5]
b. 15 Aug 1763 d. 15 Nov 1843
10
Willis Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.7.6]
b. 13 Aug 1765 d. 6 Dec 1841
9
Margaret Taft
[1.1.6.1.1.1.1.4.8]
b. 9 Feb 1729
7
Matthew Taft
[1.1.6.1.1.1.2]
b. 1642
6
Margaret Taft
[1.1.6.1.1.2]
b. 18 Mar 1617 d. 25 Aug 1684
6
Elizabeth Taft
[1.1.6.1.1.3]
b. 5 May 1620 d. 9 May 1627
6
Nicholas Taft
[1.1.6.1.1.4]
c. 21 Nov 1623 d. Aug 1624
6
Thomas Taft
[1.1.6.1.1.5]
b. 12 Oct 1625 d. 1 Dec 1625