Home Page
|
What's New
|
Photos
|
Histories
|
Headstones
|
Reports
|
Surnames
Search
First Name:
Last Name:
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Suomalainen
Svenska
Helen Herron
1495 -
Submit Photo / Document
Individual
Descendants
Relationship
Timeline
Submit Photo / Doc
Worksheet
Family
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Helen Herron
[1]
b. 1495
William Howard Taft
b. 1490
2
Nicholas Taft
[1.1]
b. 1514
Margaret Milner
b. 1514 d. 18 Mar 1617
3
Robert Taft
[1.1.1]
b. 1534 d. 9 Sep 1590
Margaret Fane
b. 1538 d. 1584
4
Nicholas Taft
[1.1.1.1]
b. 1584 d. 1 Jan 1629
Margaret Milner
b. 13 Oct 1587 d. 18 Mar 1627
5
Richard Robert Taft
[1.1.1.1.1]
b. 1614 d. 1700
Margaret Faun
b. 1620 d. 1685
6
Robert Taft
[1.1.1.1.1.1]
b. 1640 d. 8 Feb 1725
Sarah Simpson
b. 1640 d. 8 Nov 1726
7
Thomas Taft
[1.1.1.1.1.1.1]
b. 1671 d. 1755
Deborah Chenery
b. 9 Jun 1671 d. 9 Aug 1747
8
Joseph Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 26 May 1693 d. 20 Oct 1761
Hannah Cook
b. 29 Sep 1695 d. 2 Aug 1771
9
Aaron Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 26 Aug 1721 d. 4 Nov 1722
9
Joseph Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.2]
b. 15 Jan 1724 d. 1 Feb 1803
Elisabeth Cummings
d. 27 Aug 1770
10
Thomas Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1]
b. 19 Aug 1754
10
Elisabeth Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2]
b. 1 Jul 1756 d. 4 Sep 1797
10
Nathan Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3]
b. 3 Jun 1758
10
Phebe Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4]
b. 26 Nov 1760
+
Aaron Balkam
b. 1760 d. 1842
10
Eunice Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.5]
b. 11 Feb 1761 d. 1833
10
Hannah Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.6]
b. 1 Nov 1763 d. 3 Jul 1832
Eastman Taft
b. 16 Jun 1763 d. 29 Apr 1829
11
Chloe Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.6.1]
b. 7 Jul 1785 d. 25 Apr 1826
John Perry Benson
b. 22 Jul 1781 d. 21 Jan 1842
12
Charlotte Taft Benson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.1]
b. 30 Sep 1807 d. 16 Jul 1878 [
=>
]
12
Ezra Taft Benson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.2]
b. 22 Feb 1811 d. 3 Sep 1869 [
=>
]
12
George Taft Benson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.3]
b. Abt 1813 [
=>
]
12
Hannah Benson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.4]
b. 18 Sep 1816 [
=>
]
12
Abbie Ann Benson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.5]
b. Abt 1809 d. 21 Sep 1883 [
=>
]
12
John M Benson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.6]
b. 1819 d. 12 Aug 1829
11
Ezra Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.6.2]
b. 6 Mar 1793 d. 19 Feb 1808
10
Leonard Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.7]
b. 29 Mar 1767 d. 6 Feb 1846
Asenah Thayer
b. 7 Dec 1769 d. 22 Jul 1824
11
Willard Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.7.1]
b. 25 Aug 1791 d. 25 Feb 1832
Marietta Boyd
b. 1803
12
George Willard Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.7.1.1]
b. 27 Aug 1816 d. 1870
12
Susan Smith Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.7.1.2]
b. 3 Jun 1818 d. 1875
12
Asenath Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.7.1.3]
b. 21 Sep 1820 d. 18 May 1843 [
=>
]
12
Joseph Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.7.1.4]
b. 1828 d. 7 Oct 1831
12
Son Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.7.1.5]
b. 1831 d. 23 Jun 1832
11
Joseph Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.7.2]
b. 14 Oct 1793 d. 20 Dec 1869
Sophia Boyd
b. Abt 1800
12
Elmira D R Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.7.2.1]
b. 1821 [
=>
]
12
William A Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.7.2.2]
b. Abt 1836
11
Duty Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.7.3]
b. 30 Jun 1796 d. 22 Oct 1830
Judy Rounds
b. Abt 1797
12
David Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.7.3.1]
b. 13 Sep 1825 d. 26 Mar 1826
12
James Madison Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.7.3.2]
b. 27 Dec 1827 d. 21 Nov 1892
10
Cummings Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.8]
b. 27 Aug 1770 d. 22 Jun 1841
Marcy Green
b. 1 Jan 1760 d. 8 Jun 1815
11
Ezra Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.1]
b. 13 May 1797 d. 16 Nov 1878
Mercy G White
b. 1796 d. 14 Mar 1822
12
Austin Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.1.1]
b. 1 Mar 1822 d. 4 Sep 1844
Susanna Keith
b. 3 Jan 1801
12
Laura Ann M Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.1.2]
b. 26 Jun 1824 d. 26 May 1855 [
=>
]
12
Lucinda M Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.1.3]
b. 15 Mar 1826 d. 5 Mar 1906 [
=>
]
12
Artemas K Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.1.4]
b. 24 May 1828 d. 27 Dec 1878 [
=>
]
12
Uranah Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.1.5]
b. 25 Jan 1831
12
Daines C Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.1.6]
b. 1835 [
=>
]
12
Susan A Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.1.7]
b. 1838
12
Hannah Jane Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.1.8]
b. 17 Nov 1839 d. 7 Jan 1848
11
Benjamin Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.2]
b. 10 Aug 1798 d. 29 May 1799
11
Benjamin Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.3]
b. 6 May 1800 d. 17 Oct 1828
Martha Bethsheba White
b. 1803
12
Benjamin Lorin Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.3.1]
b. 25 Jun 1823
12
Russell White Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.3.2]
b. 23 Jan 1826 d. 4 Dec 1868
11
Hannah G Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.4]
b. 18 May 1802 d. 8 Jan 1843
Newell Taft
b. 28 Jul 1804 d. 4 Nov 1873
12
Albert Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.4.1]
b. 28 Aug 1823 d. Aft 1874 [
=>
]
12
Marcy Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.4.2]
b. Mar 1829 d. 12 Apr 1830
12
Charles M Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.4.3]
b. Jan 1843 d. 7 Dec 1843
9
Hannah Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.3]
b. 16 Nov 1725 d. 4 Nov 1822
Peter Keith
b. 23 Apr 1727 d. 1790
10
Joseph Keith
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.1]
b. 20 Jul 1749
10
Debora Keith
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.2]
b. 2 May 1751
10
Hannah Keith
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3]
b. 17 Jul 1753 d. 2 Apr 1842
Joseph Taft
b. 6 Jul 1751 d. 2 Jul 1828
11
Oliver Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.1]
b. 6 Nov 1771 d. 20 Feb 1853
Chloe
b. 1782 d. 24 Nov 1841
12
Olive Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.1]
b. 1 Mar 1806 d. 27 Jan 1867
12
Amariah Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.2]
b. 19 Sep 1807 d. 28 Aug 1873 [
=>
]
12
Oliver Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.3]
b. 16 Jun 1812 d. 25 Mar 1876 [
=>
]
12
Maryan Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.4]
b. 9 Jul 1814 [
=>
]
12
George Washington Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.5]
b. 13 May 1823
Laura Ann M Taft
b. 26 Jun 1824 d. 26 May 1855
12
Laura Ann Maria Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.6]
b. 7 Jul 1844
12
Son Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.7]
b. 7 Jul 1844 d. 21 Jul 1844
12
Joseph K Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.8]
b. 25 Sep 1846 d. Jul 1868
12
Chloe Jane Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.9]
b. 25 Nov 1849
11
Huldah Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.2]
b. 17 Feb 1775 d. Bef 21 May 1780
11
Huldah Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.3]
b. 21 May 1780 d. 11 Oct 1811
Parker Tyler
b. 14 Nov 1790 d. 28 Jun 1853
12
Huldah Tyler
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.3.1]
b. 4 Oct 1811 [
=>
]
12
Hannah Tyler
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.3.2]
b. 4 Oct 1811 d. 18 Oct 1811
12
Martha Almira Tyler
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.3.3]
b. 28 Sep 1830 d. 16 Oct 1909 [
=>
]
11
Hannah Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.4]
b. 29 Sep 1783
11
Peter Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.5]
b. 24 Apr 1786
10
Mary Keith
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4]
b. 17 Sep 1755
10
Esther Keith
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.5]
b. 23 Jan 1758 d. 4 Oct 1761
10
Peter Keith
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.6]
b. 3 May 1760
+
Esther Alton
b. 23 Jun 1756
10
Barak Keith
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7]
b. 25 Aug 1762 d. 26 Mar 1833
10
Marshal Keith
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.8]
b. 4 May 1765 d. 1817
10
Stephen Keith
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.9]
b. 24 Aug 1768
9
Noah Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.4]
b. 1726 d. 2 Sep 1814
Margaret Keith
b. 1733 d. 1803
10
Deborah Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.1]
b. 30 Sep 1753
+
Samuel Penniman
b. 1 Dec 1748
10
Timothy Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.2]
b. 16 Feb 1755 d. 16 Nov 1827
Abigail Wright
b. 29 Nov 1754 d. 22 Nov 1840
11
Mary Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.1]
b. 20 Jan 1780 d. 15 Nov 1863
Peter Foster
b. 11 Feb 1779 d. 15 Aug 1829
12
Taft Foster
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.1.1]
b. 7 Mar 1801 d. 16 Feb 1852
12
Loring Foster
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.1.2]
b. 19 Feb 1803
12
Luther Foster
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.1.3]
b. 6 Jan 1805 d. 9 Oct 1857
12
Eliza Foster
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.1.4]
b. 21 Dec 1806
12
Adeline Foster
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.1.5]
b. 10 Dec 1808 d. 8 May 1884
12
Emily Foster
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.1.6]
b. 13 Jan 1811 d. 1884
12
Nancy Foster
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.1.7]
b. 16 Jun 1813
12
Albert Foster
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.1.8]
b. 8 Apr 1817 d. 23 Jun 1890
12
Mary E Foster
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.1.9]
b. 25 Sep 1822
12
Demarcus Foster
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.1.10]
b. 3 Apr 1825 d. 19 Oct 1876 [
=>
]
11
Sullivan Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.2]
b. 4 Sep 1781 d. 20 Mar 1865
Sally Flagg
b. 5 Mar 1783 d. 23 Aug 1870
12
Abigail Wright Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.2.1]
b. 25 Jul 1805 d. 22 Nov 1840 [
=>
]
12
Timothy Sullivan Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.2.2]
b. 21 Dec 1806
12
Mary Flagg Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.2.3]
b. 25 Oct 1808 d. 8 Aug 1900 [
=>
]
12
Lucy Eliza Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.2.4]
b. 8 Dec 1810 d. 10 Jun 1893 [
=>
]
12
Sarah Maria Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.2.5]
b. 25 Feb 1813 d. 23 Jul 1876 [
=>
]
12
Andrew Jackson Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.2.6]
b. 17 Apr 1815 d. 16 Feb 1817
12
Andrew Jackson Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.2.7]
b. 16 Feb 1817 d. 1909 [
=>
]
12
Adoniram Judson Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.2.8]
b. 15 Dec 1819
11
Adolphus Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.3]
b. 10 Jul 1784 d. 8 Feb 1857
Polly Johnson
b. 26 Nov 1783 d. 24 Nov 1864
12
Sarah Johnson Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.3.1]
b. 29 Nov 1809
12
Mary Adaline Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.3.2]
b. 27 Jun 1812 d. 25 Feb 1895 [
=>
]
12
William Harrison Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.3.3]
b. 8 Nov 1814 d. 27 Jun 1853
12
Betsy Eaton Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.3.4]
b. 14 Jan 1817
12
Rebecca Eaton Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.3.5]
b. 14 Mar 1819
12
Sylvia Holbrook Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.3.6]
b. 28 May 1821
12
George Washington Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.3.7]
b. 29 Aug 1823
11
David Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.4]
b. 1 Jan 1786
+
Azubah Elder
b. 1790
11
Joseph Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.5]
b. 26 Jun 1791 d. 15 May 1865
10
Emmeline Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.3]
b. Abt 1757
10
Noah Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.4]
b. 14 Jan 1758 d. 25 Feb 1828
Charlotte Arnold
b. 4 Sep 1771 d. 5 Feb 1848
11
Almira Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.4.1]
b. 9 Jun 1800 d. 1873
Collins Thayer
b. 7 Apr 1790 d. 19 Sep 1855
12
Adeline Thayer
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.4.1.1]
b. 1817
12
Virginia Thayer
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.4.1.2]
b. 1821
12
Elizabeth Thayer
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.4.1.3]
b. 1823
12
Collins Thayer
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.4.1.4]
b. 1825
12
Susan Thayer
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.4.1.5]
b. 27 Dec 1826 [
=>
]
12
Olive A Thayer
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.4.1.6]
b. Abt 1827
12
Mary Thayer
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.4.1.7]
b. 1828 [
=>
]
12
Almira Thayer
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.4.1.8]
b. 1831 d. 1895
11
Arnold Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.4.2]
b. 3 Feb 1793 d. 4 Feb 1865
Nancy Thayer
b. 1786 d. 1852
12
Mary Thayer
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.4.2.1]
b. 20 Sep 1820 d. 10 Oct 1888 [
=>
]
11
Noah Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.4.3]
b. 1795 d. 31 Oct 1869
11
Charlotte A Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.4.4]
b. 1796
11
Daniel O Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.4.5]
b. 1797 d. 11 May 1871
11
Susanna Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.4.6]
b. 1798 d. 1875
11
Mary A Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.4.7]
b. 1802 d. 23 May 1804
11
Olive Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.4.8]
b. 1804
10
Keith Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.5]
b. 1761 d. 10 Sep 1825
10
Chloa Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.6]
b. 25 Nov 1763 d. 4 May 1783
Eastman Taft
b. 16 Jun 1763 d. 29 Apr 1829
11
Eastman Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.6.1]
b. 2 May 1783 d. 8 Aug 1857
10
Micajah Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.7]
b. 8 Mar 1766 d. 9 Sep 1849
10
Charlotte Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.8]
b. 10 Jun 1768
10
David Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.9]
b. 1770 d. 5 May 1832
10
Gersham Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10]
b. 1772
10
Joseph Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.11]
b. 1772 d. 23 Aug 1830
10
Charlotte Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.12]
b. 1774 d. 21 Jan 1777
9
Ezra Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.5]
b. 15 Apr 1731 d. 1761
9
Experience Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.6]
b. 7 Apr 1733 d. 15 Mar 1817
Elisha Taft
b. 3 May 1728 d. 3 Mar 1791
10
Hannah Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.1]
b. 16 Mar 1758
10
Elisha Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.2]
b. 4 Mar 1761 d. 16 Jan 1820
Mary Sadler
b. 15 Aug 1768 d. 1800
11
Hiram Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.2.1]
b. 2 Apr 1789 d. 15 Nov 1794
11
Elisha Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.2.2]
b. 23 Jul 1791 d. 26 Feb 1858
11
Ormon Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.2.3]
b. 11 Nov 1793 d. 23 Jan 1794
11
Mary Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.2.4]
b. 23 May 1795 d. 23 Feb 1875
10
Sarah Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.3]
b. 21 Mar 1763 d. 11 Oct 1835
Ezra Wood, Jr
b. 12 Mar 1759 d. 10 May 1837
11
Ezra Wood
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.3.1]
b. 25 Oct 1781
11
Experience Wood
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.3.2]
b. 16 Mar 1783 d. 14 Oct 1818
11
Sarah Wood
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.3.3]
b. 7 Aug 1784
11
Elisha Wood
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.3.4]
b. 24 Apr 1786 d. 19 Oct 1797
11
Jonathan Wood
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.3.5]
b. 8 Oct 1787 d. 26 Feb 1846
11
Anna Wood
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.3.6]
b. 31 Aug 1789 d. 20 Mar 1832
11
Chapin Wood
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.3.7]
b. 2 Apr 1792
11
Lucy Wood
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.3.8]
b. 11 Nov 1794 d. 10 Dec 1826
11
Silva Wood
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.3.9]
b. 29 Apr 1796
11
Silva Wood
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.3.10]
b. 29 Apr 1796
11
Phila Wood
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.3.11]
b. 5 Jul 1798
11
Elisha Wood
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.3.12]
b. 7 Nov 1800
11
Simeon Wood
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.3.13]
b. 5 Jan 1805
10
Israel Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.4]
b. 12 Feb 1766
10
Joseph Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.5]
b. 15 Sep 1768 d. Aft 29 Sep 1815
Sarah Farrar
b. 14 Sep 1764 d. 5 Aug 1810
11
Experience
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.5.1]
b. 5 Feb 1792
11
Amiel F Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.5.2]
b. 1 Oct 1794 d. 29 Nov 1869
11
Roxalana Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.5.3]
b. 22 Jan 1798
11
Sofrona Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.5.4]
b. 17 Jun 1800
11
Esquire Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.5.5]
b. 28 Apr 1803 d. 11 Mar 1865
11
Deborah R Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.5.6]
b. 6 Jan 1806
+
Marcy Stockwell
b. Abt 1794
9
Deborah Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.7]
b. 11 May 1735 d. 10 Dec 1738
9
Deborah Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1.8]
b. 12 Mar 1744 d. 10 Dec 1778
8
Sarah Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2]
b. 29 May 1695 d. 1719
Thomas Tenney
b. 28 May 1681
9
Elizabeth Tenney
[1.1.1.1.1.1.1.2.1]
b. Abt 1709 d. 9 Feb 1709
9
Elizabeth Tenney
[1.1.1.1.1.1.1.2.2]
b. 15 Jan 1713 d. Abt 1736
9
Phebe Tenney
[1.1.1.1.1.1.1.2.3]
b. 5 Jan 1716 d. 19 Sep 1756
8
Eleazer Taft
[1.1.1.1.1.1.1.3]
b. 5 Apr 1697 d. 29 Aug 1759
Rachel Thayer
b. 5 Mar 1700 d. 1759
9
Aaron Taft
[1.1.1.1.1.1.1.3.1]
b. 20 Jul 1722 d. 24 Apr 1764
9
Moses Taft
[1.1.1.1.1.1.1.3.2]
b. 20 Jul 1722 d. 12 Nov 1791
9
Sarah Taft
[1.1.1.1.1.1.1.3.3]
b. 2 Nov 1727
9
Joshua Taft
[1.1.1.1.1.1.1.3.4]
b. 14 Jan 1731 d. 1770
8
Hanna Taft
[1.1.1.1.1.1.1.4]
b. 17 Apr 1699
8
Rebecah Taft
[1.1.1.1.1.1.1.5]
b. 15 Mar 1701 d. 1748
8
Deborah Taft
[1.1.1.1.1.1.1.6]
b. 14 Nov 1702 d. 9 Aug 1747
Benjamin Wheelock
b. 10 Apr 1704 d. 1777
9
Benjamin Wheelock
[1.1.1.1.1.1.1.6.1]
b. 17 Aug 1729 d. 16 Apr 1776
9
Jesse Wheelock
[1.1.1.1.1.1.1.6.2]
b. 8 Sep 1731 d. Bef 4 Sep 1781
Phoebe White
b. 8 Oct 1737 d. Mar 1783
10
Phineas Wheelock
[1.1.1.1.1.1.1.6.2.1]
b. 28 Apr 1754 d. 21 Jun 1759
10
Enock Wheelock
[1.1.1.1.1.1.1.6.2.2]
b. 14 Oct 1755
10
Mary Wheelock
[1.1.1.1.1.1.1.6.2.3]
b. 23 May 1756 d. 5 Nov 1807
10
Nathan Wheelock
[1.1.1.1.1.1.1.6.2.4]
b. 20 Apr 1758
10
Nancy Wheelock
[1.1.1.1.1.1.1.6.2.5]
b. 14 Nov 1767 d. 9 Oct 1843
10
Abigail Wheelock
[1.1.1.1.1.1.1.6.2.6]
b. 16 Jan 1772
10
Baruch Wheelock
[1.1.1.1.1.1.1.6.2.7]
b. 4 Jan 1774 d. 28 Mar 1816
10
Submit Wheelock
[1.1.1.1.1.1.1.6.2.8]
b. 10 Jan 1782 d. 29 Jan 1823
9
Jonathan Wheelock
[1.1.1.1.1.1.1.6.3]
b. 8 Sep 1731 d. 1774
Ruth Daniels
b. 13 Jul 1738 d. 26 Sep 1798
10
Eleazer Wheelock
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.1]
b. 15 Jul 1756 d. 1841
10
Dole Wheelock
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.2]
b. 29 May 1758
10
Susannah Wheelock
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.3]
b. 23 Feb 1760 d. 2 May 1776
10
Lyman Wheelock
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.4]
b. 30 Nov 1761 d. 29 Mar 1848
10
Alphaeus Wheelock
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.5]
b. 17 Dec 1763
10
Willard Wheelock
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.6]
b. 19 Jun 1768 d. 29 Mar 1823
10
Deobrah Wheelock
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7]
b. 17 Dec 1765 d. 3 Aug 1846
Elkanah Benson
b. 21 Feb 1766 d. 8 Mar 1844
11
Samuel Benson
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.1]
b. 21 May 1791
Mary Van Liew
b. 8 Jul 1797 d. 22 Apr 1859
12
William Benson
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.1.1]
b. 18 Dec 1817
12
Emily Benson
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.1.2]
b. 18 Dec 1817
12
Alzina Benson
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.1.3]
b. 8 Nov 1819 d. 29 Mar 1867
12
Augustus Benson
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.1.4]
b. 10 Feb 1822
12
Phila Benson
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.1.5]
b. 8 Mar 1824 [
=>
]
12
Nathan S Benson
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.1.6]
b. 17 Sep 1826 d. 1869 [
=>
]
12
James Mapes Benson
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.1.7]
b. 12 Jun 1828 d. 11 Oct 1907 [
=>
]
12
Montgomery Benson
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.1.8]
b. Abt 1833
12
Mary Ellen Benson
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.1.9]
b. Abt 1839
11
Chloe Benson
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.2]
b. 6 Jan 1793 d. 1882
Lewis Smith
b. Abt 1790
12
Mary Smith
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.2.1]
b. Abt 1813 d. 1913
12
Sidney Smith
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.2.2]
b. 29 Jan 1815 d. 10 Sep 1900 [
=>
]
12
William Smith
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.2.3]
b. Abt 1817
12
Lewis Smith
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.2.4]
b. Abt 1820
12
Stephen Smith
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.2.5]
b. 19 Feb 1823 d. 26 Aug 1922 [
=>
]
12
Job Lewis Smith
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.2.6]
b. 15 Oct 1827 d. 9 Jun 1897
11
Adolphus Willard Benson
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.3]
b. 17 Dec 1795 d. 18 May 1878
Hannah Vermilyea
b. 1796 d. 28 Jun 1886
12
Edward Benson
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.3.1]
b. 1824
12
Bryon L Benson
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.3.2]
b. 25 Dec 1825 d. 23 Oct 1912 [
=>
]
12
Lewis Benson
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.3.3]
b. Abt 1827
12
Elizabeth Benson
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.3.4]
b. Abt 1829
12
Ellen Benson
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.3.5]
b. Abt 1831
12
John Benson
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.3.6]
b. Abt 1833
12
Henry Benson
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.3.7]
b. Abt 1835
12
Jane H Benson
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.3.8]
b. Abt 1837
12
Frank Benson
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.3.9]
b. Abt 1839
11
Eliza Benson
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.4]
b. 9 Mar 1798 d. 13 Nov 1817
+
James Miller
b. Abt 1795
11
Leonard Benson
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.5]
b. 7 Apr 1800 d. 7 Sep 1877
Ruth Ann Reynolds
b. 23 Jul 1805 d. 2 Feb 1853
12
Elisha Benson
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.5.1]
b. 1829 [
=>
]
12
William R Benson
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.5.2]
b. 1831 d. 26 Feb 1889 [
=>
]
12
John Thompson Benson
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.5.3]
b. 25 May 1833 d. 2 Apr 1914 [
=>
]
12
Emory J Benson
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.5.4]
b. Jul 1836 d. 8 Mar 1926 [
=>
]
12
Finley E Benson
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.5.5]
b. Abt 1841 [
=>
]
Hannah Sherman
12
Mary Isabelle Benson
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.5.6]
b. 7 Jun 1853 d. 9 Dec 1935 [
=>
]
11
Phila Benson
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.6]
b. 27 Jul 1802
Charles Warner
b. Abt 1800
12
Susan Warner
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.6.1]
b. 1828
12
Mary Warner
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.6.2]
b. 1830
12
Harriet Warner
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.6.3]
b. 1832
11
Calista Benson
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.7]
b. 2 Jun 1804 d. 15 Sep 1882
Jacob Conklin
b. 19 Sep 1798 d. 1 Nov 1884
12
Sarah Conklin
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.7.1]
b. 1828
12
Edward Conklin
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.7.2]
b. Abt 1828
12
Sory Ann Conklin
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.7.3]
b. 1831 d. 7 Feb 1832
12
Benson Conklin
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.7.4]
b. May 1833 [
=>
]
12
John Conklin
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.7.5]
b. 1835 d. 25 Oct 1835
12
Maria Conklin
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.7.6]
b. 1837 d. 1850
12
Daughter Conklin
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.7.7]
b. 1840 d. 1840
12
Eugene Conklin
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.7.8]
b. 1841 d. 14 Apr 1912 [
=>
]
12
Daughter Conklin
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.7.9]
b. 1843 d. 3 Mar 1843
12
Lewis Smith Conklin
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.7.10]
b. Nov 1845 d. 28 Feb 1905 [
=>
]
12
Annette Conklin
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.7.11]
b. 1848 d. 22 Jun 1848
11
Ruth Wheelock Benson
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.8]
b. 21 Sep 1807
William J Vermilyea
b. 7 Jul 1803 d. 30 Jun 1879
12
Francis Arvilla Vermilyea
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.8.1]
b. 19 Apr 1830 d. 19 Nov 1915 [
=>
]
12
Emily Benson Vermilyea
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.8.2]
b. 6 Dec 1831 d. Jun 1902 [
=>
]
12
Sidney Smith Vermilyea
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.8.3]
b. 27 Oct 1835 d. 22 Dec 1929 [
=>
]
12
Elkanah Benson Vermilyea
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.8.4]
b. 9 Sep 1837 d. 31 May 1838
12
Chauncey Vermilyea
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.8.5]
b. 25 Mar 1839 d. 16 Jun 1863
12
Eliza Prudence Vermilyea
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.8.6]
b. 4 Apr 1842 d. 1923 [
=>
]
12
John Benson Vermilyea
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.8.7]
b. 26 May 1844
12
Albert Gallatin Vermilyea
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.8.8]
b. 15 Sep 1846 [
=>
]
11
Sarah Elizabeth Benson
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.9]
b. 1 Jul 1809 d. 20 Jul 1888
Leicester Dodge
b. 28 Apr 1808 d. 5 Sep 1843
12
Ermina P Dodge
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.9.1]
b. 14 Feb 1831
12
Henry Benson Dodge
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.9.2]
b. 3 Oct 1832 d. 16 Feb 1914 [
=>
]
12
Flora Elizabeth Dodge
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.9.3]
b. 6 Nov 1834
12
Sarah Janette Dodge
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.9.4]
b. 20 Sep 1836
12
Calista Augusta Dodge
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.9.5]
b. 23 Nov 1838 d. 29 Aug 1884
12
Caroline Emelia Dodge
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.9.6]
b. 30 Aug 1841 d. 7 Dec 1913 [
=>
]
12
Lester Lewis Dodge
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7.9.7]
b. 30 Oct 1843
9
Eleazar Wheelock
[1.1.1.1.1.1.1.6.4]
b. 31 Mar 1734 d. 31 Aug 1747
8
Rachel Taft
[1.1.1.1.1.1.1.7]
b. 1 Oct 1704 d. 1752
Uriah Thayer
b. 10 Sep 1706
9
Uriah Thayer
[1.1.1.1.1.1.1.7.1]
b. 16 Mar 1728 d. 1796
9
Ebenezer Thayer
[1.1.1.1.1.1.1.7.2]
b. 1731 d. 1775
9
Eleazer Thayer
[1.1.1.1.1.1.1.7.3]
b. 1733 d. 1755
9
Rachel Thayer
[1.1.1.1.1.1.1.7.4]
b. 19 Jun 1735 d. 1783
9
Martha Thayer
[1.1.1.1.1.1.1.7.5]
b. 1736 d. 1807
9
Simeon Thayer
[1.1.1.1.1.1.1.7.6]
b. 20 Oct 1739 d. 1764
8
Martha Taft
[1.1.1.1.1.1.1.8]
b. 15 Jun 1708 d. 6 Jan 1753
Joseph Benson
b. 14 Oct 1712 d. 24 Feb 1786
9
Moses Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1]
b. 20 May 1732 d. 3 Jul 1806
Eunice Holbrook
b. 9 Aug 1735 d. Aft 1790
10
Aaron Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.1]
b. 28 Oct 1753 d. 8 Jul 1827
Lydia Fairbanks
b. 1758 d. 30 Aug 1814
11
Alanson Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.1.1]
b. 1783 d. 7 Dec 1857
Lucina Lapham
b. Abt 1789 d. Nov 1853
12
Lucina Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.1.1.1]
b. 28 Jan 1832 d. 1 Jan 1916
11
Polly Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.1.2]
b. 9 Apr 1785 d. 3 Dec 1847
Ebenezer Balcom
b. 14 Apr 1783 d. 14 Oct 1836
12
Aaron Balcom
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.1.2.1]
b. 1805
12
Joel Chapin Balcom
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.1.2.2]
b. Abt 1807
12
Mary Balcom
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.1.2.3]
b. Abt 1809
11
Aaron Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.1.3]
b. 10 Mar 1788
11
Ellis Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.1.4]
b. 13 Oct 1792 d. 31 Mar 1830
11
Lydia Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.1.5]
b. 15 Oct 1798
Arnold White
b. 5 Mar 1800
12
Charles White
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.1.5.1]
b. 1825 d. 25 Mar 1899 [
=>
]
10
David Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.2]
b. 23 Dec 1756 d. 8 Mar 1847
Zilla Marsh
b. 29 Aug 1760 d. 18 Jan 1817
11
Jessie Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.2.1]
b. 14 Mar 1781 d. Abt 1846
Olive Wheeler
b. 14 Feb 1788 d. 24 Aug 1846
12
Alanson Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.2.1.1]
b. Abt 1807
12
Lyman David Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.2.1.2]
b. Abt 1808 d. 1884
12
Susanna Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.2.1.3]
b. 1809 d. 9 Jun 1825
12
Laura Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.2.1.4]
b. Abt 1809
12
Olive Maria Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.2.1.5]
b. 1810 d. 1885
12
L Lavina Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.2.1.6]
b. 10 Oct 1810
12
Lanson Wheeler Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.2.1.7]
b. 9 Dec 1813
12
Flora Zillah Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.2.1.8]
b. 27 Jul 1815 d. 25 Apr 1875
12
Lyman Daniel Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.2.1.9]
b. 21 Aug 1817
12
Addison Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.2.1.10]
b. 7 May 1822 d. 16 Jul 1873
12
Anderson Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.2.1.11]
b. 7 May 1822 d. 1898
11
Betsey Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.2.2]
b. 27 Jun 1782
11
Asenath Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.2.3]
b. 16 Feb 1784
11
Phineas Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.2.4]
b. 31 May 1785 d. 15 Mar 1835
Polly Lucretia Frost
b. 1787 d. 14 May 1864
12
Luman Austin Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.2.4.1]
b. 21 Nov 1812
12
Benjamin McClure Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.2.4.2]
b. 21 Oct 1816 d. Aug 1858
12
Phineas Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.2.4.3]
b. 21 Oct 1816
12
Paulina Lucretia Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.2.4.4]
b. 27 May 1820
12
Eliza Ann Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.2.4.5]
b. 30 Jan 1823
12
Merrill H Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.2.4.6]
b. 14 Feb 1826 d. 25 Dec 1880
11
Levina Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.2.5]
b. 6 Sep 1786
11
Cyrus Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.2.6]
b. 23 Dec 1787
11
Matilda Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.2.7]
b. 10 Apr 1789
11
David Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.2.8]
b. 10 Apr 1789 d. 19 Oct 1868
Lucinda Adams
b. 1792 d. 2 Apr 1836
12
Son Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.2.8.1]
b. 24 Mar 1818
12
Cyrus Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.2.8.2]
b. 15 Feb 1819 d. 1895
12
David E Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.2.8.3]
b. 19 Mar 1820 d. 28 Dec 1895
12
Sally A Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.2.8.4]
b. 10 Mar 1821 d. 31 Aug 1823
12
Edwin Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.2.8.5]
b. 16 Mar 1822 d. 11 Sep 1852
12
Enoch Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.2.8.6]
b. 4 May 1823 d. 1901
12
Elliot Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.2.8.7]
b. 3 Aug 1824
12
Hannah Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.2.8.8]
b. 12 Sep 1825
12
Henry H Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.2.8.9]
b. 30 Sep 1827
12
Mary Louisa Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.2.8.10]
b. 8 Apr 1830
12
George D Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.2.8.11]
b. 18 Nov 1831
12
Merrick C Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.2.8.12]
b. 25 Oct 1833 d. Abt 1860
11
Moses Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.2.9]
b. 1 Oct 1792
+
Mary Howard
11
Lewis Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.2.10]
b. 21 Jan 1794
+
Maria Atwood
b. 6 May 1801
11
Danford Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.2.11]
b. 1 Jul 1794 d. 14 Feb 1859
Content Adams
b. 9 Mar 1800 d. 25 Sep 1877
12
Danforth Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.2.11.1]
b. 2 Aug 1820 d. 25 Jul 1872
12
Luna Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.2.11.2]
b. 10 Jul 1822
12
Lumen P Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.2.11.3]
b. 11 Aug 1824
11
Willard Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.2.12]
b. 7 Apr 1797
11
Susannah Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.2.13]
b. 7 Oct 1798 d. 4 Jan 1817
11
Hannah Azuba Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.2.14]
b. 4 Jul 1801
11
Albey Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.2.15]
b. 27 Aug 1804
10
Keziah Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.3]
b. 1 Mar 1759 d. Abt 1800
10
Daniel Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.4]
b. 1 Jun 1761 d. 9 Oct 1854
Phebe Bugbee
b. 1762 d. 3 May 1855
11
Annie Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.4.1]
b. 28 Mar 1787
11
Daniel Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.4.2]
b. 18 May 1788
11
John Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.4.3]
b. 19 Mar 1789
11
Mary Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.4.4]
b. 28 May 1791
11
Ebenezer Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.4.5]
b. 4 Sep 1793 d. 11 Mar 1870
+
Lucinda
11
Melinda Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.4.6]
b. 25 Jul 1795
11
Orrison Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.4.7]
b. 31 Aug 1797 d. 24 Apr 1883
+
Mary Williams
b. 1800
11
Sally Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.4.8]
b. 30 Jul 1799
John Kneeland
b. Abt 1795
12
Ichabod Kneeland
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.4.8.1]
b. Abt 1821
11
Arza Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.4.9]
b. 7 Jul 1803
11
James Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.4.10]
b. 3 Jan 1805
11
Chester Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.4.11]
b. 26 Jan 1807 d. 19 Aug 1889
Florilla Williams
b. 8 Sep 1806 d. 14 Dec 1889
12
Cyntha Elnora Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.4.11.1]
b. 3 Oct 1827
12
Ellen Mariah Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.4.11.2]
b. 22 Aug 1829
12
Harriet Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.4.11.3]
b. 20 Sep 1831
12
Arza Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.4.11.4]
b. 13 Jul 1833
12
Walter Williams Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.4.11.5]
b. 5 Apr 1835 d. 5 Feb 1905
12
Chester Seldin Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.4.11.6]
b. 27 Mar 1837
12
Henry E. Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.4.11.7]
b. 6 May 1839
12
Harlon Clinton Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.4.11.8]
b. 2 May 1841
12
Meredith Mosell Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.4.11.9]
b. 7 Apr 1843
12
Lucy Marion Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.4.11.10]
b. 5 Jun 1845 d. 12 Jul 1916
12
Herbert Leslie Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.4.11.11]
b. 5 Dec 1847
12
Florilla Ada Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.4.11.12]
b. 22 Dec 1851
11
Cynthia Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.4.12]
b. 16 Jan 1809
11
Fanny Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.4.13]
b. 2 Jun 1811
10
Peter Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.5]
b. 16 Jul 1763 d. 23 Mar 1854
10
Jesse Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.6]
b. 19 Feb 1766
10
Anna Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.7]
b. 6 Aug 1767
10
Hannah Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.8]
b. 3 Mar 1770
10
Susanna Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.9]
b. 26 Aug 1772
10
Eunice Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.10]
b. 4 May 1775
9
Joseph Benson, Jr
[1.1.1.1.1.1.1.8.2]
b. 22 Oct 1735 d. 12 Jan 1818
9
Aaron Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.3]
b. 20 May 1738 d. 7 Nov
9
Benjamin Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.4]
b. 3 Mar 1742 d. 29 Mar 1802
Martha McNamara
b. 11 Mar 1745 d. 15 Sep 1806
10
Amasa Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.4.1]
b. 15 Mar 1770 d. 28 Oct 1777
10
Timothy Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.4.2]
b. 19 Aug 1771 d. 22 Oct 1777
10
Silence Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.4.3]
b. 30 Jul 1773 d. 10 Nov 1777
10
Hannah Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.4.4]
b. 18 Apr 1775 d. 22 Apr 1831
+
Asahel Pelton
b. 3 Aug 1773 d. 27 Mar 1857
10
Martha Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.4.5]
b. 26 Feb 1777
Timatha Gleason
b. 2 Aug 1779 d. 4 May 1841
11
Lucy Gleason
[1.1.1.1.1.1.1.8.4.5.1]
b. 2 Feb 1804
+
Curtis P Howe
11
Mary Gleason
[1.1.1.1.1.1.1.8.4.5.2]
b. 23 Jul 1807
+
Wyman Fay
11
Fidelia Gleason
[1.1.1.1.1.1.1.8.4.5.3]
b. 9 Jan 1811 d. Bef 1922
+
Lorin Davis
b. 1809
11
George G Gleason
[1.1.1.1.1.1.1.8.4.5.4]
b. 27 Aug 1815
11
Martha Ann Gleason
[1.1.1.1.1.1.1.8.4.5.5]
b. 16 Sep 1821
11
Martha Gleason
[1.1.1.1.1.1.1.8.4.5.6]
b. 27 Sep 1822
10
Amasa Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.4.6]
b. 15 Feb 1779 d. 22 Feb 1847
10
Silence Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.4.7]
b. 8 Aug 1781 d. 4 Sep 1829
+
Clark Adams
b. 5 Nov 1773
10
Thankful Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.4.8]
b. 29 Aug 1783 d. 11 Apr 1808
Otis Taft
b. 17 Sep 1786 d. 19 Nov 1827
11
Tilus Vespasian Taft
[1.1.1.1.1.1.1.8.4.8.1]
b. 4 Jun 1806 d. 22 Feb 1889
Sarah Jane Hagar
b. 16 Dec 1810 d. 25 Sep 1852
12
Louis V Taft
[1.1.1.1.1.1.1.8.4.8.1.1]
b. 2 Oct 1831
12
Abby Jane Taft
[1.1.1.1.1.1.1.8.4.8.1.2]
b. 30 Oct 1836 d. 1906
12
Georgiana Taft
[1.1.1.1.1.1.1.8.4.8.1.3]
b. 31 Mar 1839 d. 9 Oct 1918
12
James K Polk Taft
[1.1.1.1.1.1.1.8.4.8.1.4]
b. 17 May 1847 d. 15 Sep 1847
12
Sarah Taft
[1.1.1.1.1.1.1.8.4.8.1.5]
b. 21 Sep 1852 d. 21 Sep 1852
Katharine Edwards
b. 22 Dec 1815 d. 22 Feb 1878
12
Henry Taft
[1.1.1.1.1.1.1.8.4.8.1.6]
b. 12 Nov 1854 d. 12 Nov 1854
12
Edward Taft
[1.1.1.1.1.1.1.8.4.8.1.7]
b. 7 Feb 1858 d. 9 May 1930
11
Benjamin B Taft
[1.1.1.1.1.1.1.8.4.8.2]
b. 28 Feb 1808
10
Benjamin Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.4.9]
b. 6 Jun 1786 d. 18 Mar 1815
10
Truelove Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.4.10]
b. 18 Nov 1788 d. 1 Aug 1837
+
Jonas Johnson
9
Abner Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.5]
b. Abt 1750
Experience Muxsom
b. 1753
10
Martha Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.5.1]
b. 27 Oct 1771 d. 7 Dec 1850
David Davis
b. 16 Oct 1767 d. 19 Nov 1811
11
Lucy Davis
[1.1.1.1.1.1.1.8.5.1.1]
b. 14 Apr 1791 d. 1822
Elisha Snell
12
Lucy Attie Shell
[1.1.1.1.1.1.1.8.5.1.1.1]
b. 1 Oct 1813 [
=>
]
11
David Davis
[1.1.1.1.1.1.1.8.5.1.2]
b. 21 Dec 1792
Roxanna Barr
b. 13 Feb 1790
12
William Davis
[1.1.1.1.1.1.1.8.5.1.2.1]
b. 26 Oct 1810
12
Hosiah Davis
[1.1.1.1.1.1.1.8.5.1.2.2]
b. 4 May 1812
12
Charles Davis
[1.1.1.1.1.1.1.8.5.1.2.3]
b. 17 Sep 1814 [
=>
]
12
Sarah Davis
[1.1.1.1.1.1.1.8.5.1.2.4]
b. 10 Aug 1816 [
=>
]
12
Sally Davis
[1.1.1.1.1.1.1.8.5.1.2.5]
b. 10 Aug 1816
12
Mary Davis
[1.1.1.1.1.1.1.8.5.1.2.6]
b. 5 May 1819 [
=>
]
Elizabeth Clark Spaulding
b. 1799 d. 21 Dec 1872
12
Philena Laurette Davis
[1.1.1.1.1.1.1.8.5.1.2.7]
b. 11 Feb 1822 d. 22 Jan 1903
12
Suel Spaulding Davis
[1.1.1.1.1.1.1.8.5.1.2.8]
b. 30 Mar 1824 d. 27 Apr 1904
12
Lyman Uberto Davis
[1.1.1.1.1.1.1.8.5.1.2.9]
b. Abt 1826
12
William Clark Davis
[1.1.1.1.1.1.1.8.5.1.2.10]
b. Abt 1830
12
John Warren Davis
[1.1.1.1.1.1.1.8.5.1.2.11]
b. Abt 1831 d. 6 Oct 1913
12
Susan Almirao Davis
[1.1.1.1.1.1.1.8.5.1.2.12]
b. 11 Nov 1834 d. 20 Nov 1903
12
George Willoughby Davis
[1.1.1.1.1.1.1.8.5.1.2.13]
b. 18 Nov 1839
12
Theresa Isadore Davis
[1.1.1.1.1.1.1.8.5.1.2.14]
b. Abt 19 Jun 1846 d. 13 Oct 1924
12
David Gordon Davis
[1.1.1.1.1.1.1.8.5.1.2.15]
11
Hiram Davis
[1.1.1.1.1.1.1.8.5.1.3]
b. Abt 1793
Eliza H Wheeler
b. 24 Feb 1799
12
William Davis
[1.1.1.1.1.1.1.8.5.1.3.1]
b. 1819 d. 20 Jan 1821
12
Caroline Davis
[1.1.1.1.1.1.1.8.5.1.3.2]
b. 1820
12
Martha Davis
[1.1.1.1.1.1.1.8.5.1.3.3]
b. 1820
12
Francis Davis
[1.1.1.1.1.1.1.8.5.1.3.4]
b. 1820
12
Geroge Davis
[1.1.1.1.1.1.1.8.5.1.3.5]
b. 1820
11
Abner Davis
[1.1.1.1.1.1.1.8.5.1.4]
b. 21 Sep 1795 d. 10 Dec 1874
Lucy Oaks
b. Abt 1794 d. 1827
12
Harriet C Davis
[1.1.1.1.1.1.1.8.5.1.4.1]
b. 13 Nov 1821 d. 3 Aug 1887
12
Andrew J Davis
[1.1.1.1.1.1.1.8.5.1.4.2]
b. 1826 d. 10 Mar 1910
12
Sarah Y Davis
[1.1.1.1.1.1.1.8.5.1.4.3]
b. 13 Mar 1829 d. 15 Dec 1916
12
Frances Carolyn Davis
[1.1.1.1.1.1.1.8.5.1.4.4]
b. 2 Nov 1833 d. 30 Aug 1885
11
Suel Davis
[1.1.1.1.1.1.1.8.5.1.5]
b. 13 Apr 1798 d. 28 Sep 1872
Lucy Wheeler
b. 5 Oct 1792 d. 27 Mar 1860
12
Charles C Davis
[1.1.1.1.1.1.1.8.5.1.5.1]
b. 6 Nov 1822 d. 4 Apr 1903
12
Edwin Davis
[1.1.1.1.1.1.1.8.5.1.5.2]
b. 1824
10
Lucy Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.5.2]
b. 16 Apr 1774 d. 11 Dec 1815
10
Dennis Benson
[1.1.1.1.1.1.1.8.5.3]
b. 24 Jan 1777
8
Isaac Taft
[1.1.1.1.1.1.1.9]
b. 15 Jul 1710 d. 11 Oct 1776
Deborah White
b. 1711
9
Isaac Taft
[1.1.1.1.1.1.1.9.1]
b. 1743
9
Jonathan Taft
[1.1.1.1.1.1.1.9.2]
b. 5 Jan 1745 d. 1810
9
Artemas Taft
[1.1.1.1.1.1.1.9.3]
b. 28 Dec 1750 d. 1 Aug 1837
9
Susannah Taft
[1.1.1.1.1.1.1.9.4]
b. 1753 d. 2 Apr 1819
9
Timothy Taft
[1.1.1.1.1.1.1.9.5]
b. 1757 d. 1824
9
Mary Taft
[1.1.1.1.1.1.1.9.6]
b. 1761
8
Thomas Taft
[1.1.1.1.1.1.1.10]
b. 5 Apr 1713 d. 25 Jan 1793
Lydia Thompson
b. 10 Dec 1710 d. Aft 1756
9
Thomas Taft
[1.1.1.1.1.1.1.10.1]
b. 14 May 1736 d. 15 May 1736
9
Kezia Taft
[1.1.1.1.1.1.1.10.2]
b. 7 May 1737 d. 3 Jul 1737
9
Lydia Taft
[1.1.1.1.1.1.1.10.3]
b. 18 May 1738 d. 29 Jan 1829
9
Charity Taft
[1.1.1.1.1.1.1.10.4]
b. 24 Nov 1742 d. 22 Aug 1747
9
Hannah Taft
[1.1.1.1.1.1.1.10.5]
b. 6 Mar 1745
9
Nathaniel Taft
[1.1.1.1.1.1.1.10.6]
b. 15 Oct 1747 d. 12 Aug 1827
9
Amariah Taft
[1.1.1.1.1.1.1.10.7]
b. 13 Feb 1750 d. 2 Mar 1750
9
Thomas Taft, Jr
[1.1.1.1.1.1.1.10.8]
b. 30 Oct 1753 d. 8 Jan 1835
Betsey Fletcher
b. 1772 d. 20 Sep 1819
10
Thomas Arnold Taft
[1.1.1.1.1.1.1.10.8.1]
b. 22 May 1794 d. 16 Apr 1871
Martha Willard Harrington
b. 16 Sep 1797 d. 10 Jan 1888
11
Betsey Willard Taft
[1.1.1.1.1.1.1.10.8.1.1]
b. 28 Nov 1815
11
Charlott Taft
[1.1.1.1.1.1.1.10.8.1.2]
b. 7 Jul 1817 d. 22 Feb 1883
11
Lewis Willard Taft
[1.1.1.1.1.1.1.10.8.1.3]
b. 19 May 1819
11
Arnold Austin Taft
[1.1.1.1.1.1.1.10.8.1.4]
b. 31 Dec 1820 d. 22 May 1853
11
George Taft
[1.1.1.1.1.1.1.10.8.1.5]
b. 10 Apr 1822 d. 7 Dec 1852
11
David Henry Taft
[1.1.1.1.1.1.1.10.8.1.6]
b. 31 Dec 1823
11
Martha Taft
[1.1.1.1.1.1.1.10.8.1.7]
b. 23 Feb 1826 d. 19 Feb 1903
Jared Benson
b. 8 Nov 1821 d. 18 May 1894
12
Sullivan Theodore Benson
[1.1.1.1.1.1.1.10.8.1.7.1]
b. 20 Apr 1844 d. 21 Sep 1911
12
Jared Irving Benson
[1.1.1.1.1.1.1.10.8.1.7.2]
b. 6 Oct 1846 d. 1919 [
=>
]
12
Walter Bryant Benson
[1.1.1.1.1.1.1.10.8.1.7.3]
b. 16 Jan 1850 d. 10 Feb 1860
12
Grace Sally Benson
[1.1.1.1.1.1.1.10.8.1.7.4]
b. 2 Sep 1852 d. 25 Feb 1863
11
Stephen Claridon Taft
[1.1.1.1.1.1.1.10.8.1.8]
b. 30 Sep 1827 d. 23 Jan 1905
11
Charles Taft
[1.1.1.1.1.1.1.10.8.1.9]
b. 4 Oct 1829
11
Adin Ballou Taft
[1.1.1.1.1.1.1.10.8.1.10]
b. 7 Nov 1831
11
Waterman Taft
[1.1.1.1.1.1.1.10.8.1.11]
b. 13 Nov 1833
11
James Edward Taft
[1.1.1.1.1.1.1.10.8.1.12]
b. 4 Apr 1836
11
Jane Ellen Taft
[1.1.1.1.1.1.1.10.8.1.13]
b. 4 Apr 1836
11
Anna Sophia Taft
[1.1.1.1.1.1.1.10.8.1.14]
b. 7 Jul 1839
11
Julia August Freemon Taft
[1.1.1.1.1.1.1.10.8.1.15]
b. 29 Mar 1841 d. 15 Nov 1842
10
Stephen Taft
[1.1.1.1.1.1.1.10.8.2]
b. 30 Nov 1795
10
Thomas Taft, Jr
[1.1.1.1.1.1.1.10.8.3]
b. 26 Dec 1797 d. 24 Sep 1872
10
Betsey Taft
[1.1.1.1.1.1.1.10.8.4]
b. 7 Oct 1804
9
Genery Taft
[1.1.1.1.1.1.1.10.9]
b. 3 Jun 1756 d. 17 Aug 1761
8
Susanna Taft
[1.1.1.1.1.1.1.11]
b. 15 Mar 1714 d. 8 Nov 1751
John Fish
b. 30 Jun 1715 d. Aft 1772
9
Deborah Fish
[1.1.1.1.1.1.1.11.1]
b. 13 Feb 1741 d. 5 Mar 1826
9
Hannah Fish
[1.1.1.1.1.1.1.11.2]
b. 25 Jun 1744 d. 20 Sep 1836
9
Simeon Fish
[1.1.1.1.1.1.1.11.3]
b. 1747 d. 1825
9
Lydia Fish
[1.1.1.1.1.1.1.11.4]
b. 8 Sep 1749
9
John Fish
[1.1.1.1.1.1.1.11.5]
b. 7 Nov 1751 d. 7 Nov 1751
7
Robert Taft Jr
[1.1.1.1.1.1.2]
b. Abt 1674 d. 29 Apr 1748
Elizabeth Woodward
b. 15 Jun 1670 d. 7 Aug 1753
8
Robert Taft
[1.1.1.1.1.1.2.1]
b. 24 Dec 1697 d. 6 Mar 1776
Mary Chapin
b. 30 Apr 1700 d. 22 Jan 1768
9
Bethiah Taft
[1.1.1.1.1.1.2.1.1]
b. 21 Dec 1721 d. 30 May 1741
9
Elizabeth Taft
[1.1.1.1.1.1.2.1.2]
b. 18 Jun 1723 d. 1779
9
Deborah Keith
[1.1.1.1.1.1.2.1.3]
b. 20 Feb 1728 d. 11 Apr 1806
9
Seth Taft
[1.1.1.1.1.1.2.1.4]
b. 27 Oct 1729 d. 15 Feb 1794
9
Jesse Taft
[1.1.1.1.1.1.2.1.5]
b. 4 Apr 1731 d. 1753
9
Abigail Taft
[1.1.1.1.1.1.2.1.6]
b. 20 Jan 1737
9
Ebenezer Taft
[1.1.1.1.1.1.2.1.7]
b. 8 Aug 1732 d. 3 Oct 1836
Polly Hayward
b. 10 Oct 1760 d. 15 Aug 1848
10
Enos Taft
[1.1.1.1.1.1.2.1.7.1]
b. 8 Dec 1779 d. 29 Dec 1812
10
Betsey Taft
[1.1.1.1.1.1.2.1.7.2]
b. 11 Jun 1781
10
Putman Taft
[1.1.1.1.1.1.2.1.7.3]
b. 5 Aug 1783 d. 20 Feb 1810
Abigail Benson
b. 13 Feb 1787
11
Mary Ann Taft
[1.1.1.1.1.1.2.1.7.3.1]
b. 23 Oct 1807
+
Samuel T Holroyd
b. 1791 d. 4 Nov 1817
+
Angel Sweet
b. 7 Apr 1790 d. 28 Apr 1825
+
Edward Ide Bower
+
Joseph McDermott
10
Polly Taft
[1.1.1.1.1.1.2.1.7.4]
b. 20 Jun 1785
10
Salley Taft
[1.1.1.1.1.1.2.1.7.5]
b. 21 Oct 1787 d. 7 Aug 1855
Jared Benson
b. 3 Feb 1785 d. 31 Jul 1854
11
James Sulliven Benson
[1.1.1.1.1.1.2.1.7.5.1]
b. 19 Sep 1808 d. 3 Jan 1833
11
Putman Taft Benson
[1.1.1.1.1.1.2.1.7.5.2]
b. 28 Oct 1814 d. 24 Apr 1834
11
Jared Benson
[1.1.1.1.1.1.2.1.7.5.3]
b. 8 Nov 1821 d. 18 May 1894
Martha Taft
b. 23 Feb 1826 d. 19 Feb 1903
12
Sullivan Theodore Benson
[1.1.1.1.1.1.2.1.7.5.3.1]
b. 20 Apr 1844 d. 21 Sep 1911
12
Jared Irving Benson
[1.1.1.1.1.1.2.1.7.5.3.2]
b. 6 Oct 1846 d. 1919 [
=>
]
12
Walter Bryant Benson
[1.1.1.1.1.1.2.1.7.5.3.3]
b. 16 Jan 1850 d. 10 Feb 1860
12
Grace Sally Benson
[1.1.1.1.1.1.2.1.7.5.3.4]
b. 2 Sep 1852 d. 25 Feb 1863
11
Sylvanus Holbrook Benson
[1.1.1.1.1.1.2.1.7.5.4]
b. 23 Jun 1828 d. 1878
Laurett V Howard
b. 1830 d. 1860
12
Ellen Laura Benson
[1.1.1.1.1.1.2.1.7.5.4.1]
b. 18 Aug 1851 [
=>
]
12
Ernest S Benson
[1.1.1.1.1.1.2.1.7.5.4.2]
b. 25 May 1855
12
Laurett Victoria Howard Benson
[1.1.1.1.1.1.2.1.7.5.4.3]
b. 1859 d. 3 Jul 1883 [
=>
]
Lottie E. Kelly
12
Lottie E. Benson
[1.1.1.1.1.1.2.1.7.5.4.4]
b. 20 Sep 1866
10
Chloe Taft
[1.1.1.1.1.1.2.1.7.6]
b. 7 Nov 1789
10
Deborah Taft
[1.1.1.1.1.1.2.1.7.7]
b. 21 Feb 1791 d. 14 Feb 1813
10
Leonard Taft
[1.1.1.1.1.1.2.1.7.8]
b. 17 Jun 1794 d. 25 Sep 1872
Martha Comstock
b. 17 Nov 1798 d. 14 May 1853
11
Hannah Mariah Taft
[1.1.1.1.1.1.2.1.7.8.1]
b. 11 Jul 1824 d. 31 Jul 1844
11
Enos Nelson Taft
[1.1.1.1.1.1.2.1.7.8.2]
b. 12 Aug 1826
11
Leonard Almond Taft
[1.1.1.1.1.1.2.1.7.8.3]
b. 22 Jul 1828 d. 29 Jul 1857
11
Edward Henry Taft
[1.1.1.1.1.1.2.1.7.8.4]
b. 1 Jul 1830
10
Phila Taft
[1.1.1.1.1.1.2.1.7.9]
b. 25 Mar 1796 d. 26 Mar 1813
10
Ellis Taft
[1.1.1.1.1.1.2.1.7.10]
b. 23 May 1796 d. 27 Aug 1851
+
Aseneth Boyden
b. 10 Sep 1794 d. Apr 1886
10
Nancy Taft
[1.1.1.1.1.1.2.1.7.11]
b. 14 Aug 1801 d. 14 Jan 1849
8
Israel Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2]
b. 26 Apr 1699 d. 19 Sep 1753
Mercy Aldrich
b. 21 Jun 1700 d. Aft 19 Sep 1753
9
Huldah Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.1]
b. 28 Jun 1718 d. 2 Jul 1799
David Daniels
b. 4 Jul 1710 d. 21 May 1776
10
Ruth Daniels
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.1]
b. 13 Jul 1738 d. 26 Sep 1798
Jonathan Wheelock
b. 8 Sep 1731 d. 1774
11
Eleazer Wheelock
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.1.1]
b. 15 Jul 1756 d. 1841
11
Dole Wheelock
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.1.2]
b. 29 May 1758
11
Susannah Wheelock
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.1.3]
b. 23 Feb 1760 d. 2 May 1776
11
Lyman Wheelock
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.1.4]
b. 30 Nov 1761 d. 29 Mar 1848
11
Alphaeus Wheelock
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.1.5]
b. 17 Dec 1763
11
Willard Wheelock
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.1.6]
b. 19 Jun 1768 d. 29 Mar 1823
11
Deobrah Wheelock
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.1.7]
b. 17 Dec 1765 d. 3 Aug 1846
Elkanah Benson
b. 21 Feb 1766 d. 8 Mar 1844
12
Samuel Benson
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.1]
b. 21 May 1791 [
=>
]
12
Chloe Benson
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.2]
b. 6 Jan 1793 d. 1882 [
=>
]
12
Adolphus Willard Benson
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.3]
b. 17 Dec 1795 d. 18 May 1878 [
=>
]
12
Eliza Benson
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.4]
b. 9 Mar 1798 d. 13 Nov 1817
12
Leonard Benson
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.5]
b. 7 Apr 1800 d. 7 Sep 1877 [
=>
]
12
Phila Benson
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.6]
b. 27 Jul 1802 [
=>
]
12
Calista Benson
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.7]
b. 2 Jun 1804 d. 15 Sep 1882 [
=>
]
12
Ruth Wheelock Benson
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.8]
b. 21 Sep 1807 [
=>
]
12
Sarah Elizabeth Benson
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.9]
b. 1 Jul 1809 d. 20 Jul 1888 [
=>
]
Abraham Staples
b. 4 Apr 1731 d. 20 Oct 1803
11
Ruth Staples
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.1.8]
b. 22 Feb 1775 d. 10 Aug 1851
Elias Thayer
b. 3 May 1773 d. 26 Jun 1833
12
Hannah Ellis Thayer
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.1.8.1]
b. 19 Mar 1800 d. 26 Feb 1818 [
=>
]
12
Ruth Daniels Thayer
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.1.8.2]
b. 16 Jul 1802
12
Mary Blake Thayer
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.1.8.3]
b. 26 Nov 1804 d. 1870
12
Elias Thayer
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.1.8.4]
b. 28 Oct 1806 d. 2 Nov 1808
12
Julia Ann Thayer
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.1.8.5]
b. 13 Dec 1808 d. 6 Aug 1833
12
Lyman Wheelock Thayer
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.1.8.6]
b. 6 May 1798 d. 5 Apr 1848
12
Susan Thayer
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.1.8.7]
b. 1 Feb 1811 d. 7 Apr 1812
12
Elias Nelson Thayer
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.1.8.8]
b. 3 Apr 1814 d. 6 Aug 1835
12
John Milton Thayer
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.1.8.9]
b. 24 Jan 1820 d. 19 Mar 1906
11
Lendol Staples
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.1.9]
b. 1777
11
Susannah Staples
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.1.10]
b. 21 Jul 1780 d. 11 Feb 1818
10
Daniel Daniels
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.2]
b. 4 Nov 1740 d. 24 May 1832
Ruth Aldrich
b. 29 Jun 1741 d. 15 Jul 1801
11
Rachael Daniels
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.2.1]
b. 24 Dec 1767 d. 11 Aug 1846
11
Nathan Daniels
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.2.2]
b. 1769 d. 10 May 1839
11
Dianah Daniels
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.2.3]
b. 1774
11
Hulda Daniels
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.2.4]
b. 1776
11
Adolpheus Daniels
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.2.5]
b. 1778
11
Waite Daniels
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.2.6]
b. 1780
+
Nancy Thayer
b. Abt 1743 d. 10 Mar 1803
10
Molly Daniels
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.3]
b. 1 Oct 1741 d. 13 Apr 1793
Seth Kelley
b. 26 Nov 1730 d. 29 Apr 1799
11
Seth Kelley
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.3.1]
b. 10 Sep 1762 d. 27 Sep 1850
11
Mehitable Kelley
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.3.2]
b. 30 Apr 1765 d. 4 Nov 1798
11
Lettice Kelley
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.3.3]
b. 9 Jan 1768 d. 1 Feb 1843
11
Willis Kelley
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.3.4]
b. 14 Jan 1770 d. 23 Dec 1826
11
Moses Kelley
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.3.5]
b. 19 Oct 1771 d. 14 Sep 1776
11
Waite Kelley
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.3.6]
b. 12 Aug 1773 d. 7 Mar 1781
11
Asa Kelley
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.3.7]
b. 24 Mar 1775 d. 29 Apr 1852
11
John Kelley
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.3.8]
b. 12 Dec 1776 d. 17 Aug 1866
11
Daniel Kelley
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.3.9]
b. 23 Jul 1778 d. 23 Apr 1825
11
Mary Kelley
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.3.10]
b. 6 Jul 1780 d. 26 Feb 1802
11
Mark Kelley
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.3.11]
b. 1783 d. 12 Feb 1852
11
Hulda Kelley
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.3.12]
b. 1 Mar 1785 d. 29 Mar 1785
11
David Kelly
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.3.13]
b. 1786
10
Azor Daniels
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.4]
b. 20 Feb 1743 d. 19 Sep 1748
10
Chloe Daniels
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.5]
b. 13 Sep 1745 d. 19 May 1823
Seth Davenport
b. 2 Nov 1739 d. 28 Mar 1813
11
Anna Davenport
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.5.1]
b. 8 Sep 1765 d. 1 Aug 1842
William Torrey
b. 23 Nov 1754 d. 16 Sep 1817
12
Samuel Davenport Torrey
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.5.1.1]
b. 14 Apr 1789 d. 23 Dec 1877 [
=>
]
12
Joseph Torrey
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.5.1.2]
b. 4 Oct 1790 d. 15 Nov 1836 [
=>
]
12
Louisa Torrey
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.5.1.3]
b. 29 Mar 1792 d. 10 Jul 1874
12
Benjamin Torrey
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.5.1.4]
b. 5 Mar 1794 d. 20 Oct 1797
12
Stephen Torrey
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.5.1.5]
b. 25 Mar 1796 d. 29 Apr 1875
12
Benjamin Davenport Torrey
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.5.1.6]
b. 19 Dec 1803 d. 24 Jun 1826
12
George Washington Torrey
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.5.1.7]
b. 26 Oct 1806 d. 3 Oct 1885 [
=>
]
+
Peter Holbrook
11
David Davenport
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.5.2]
b. 17 Jan 1767
11
Mary Davenport
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.5.3]
b. 30 Sep 1768
11
Rebecca Davenport
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.5.4]
b. 9 Apr 1770 d. 15 May 1794
11
Samuel Daniels Davenport
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.5.5]
b. 14 Oct 1772 d. 13 Feb 1802
11
Chloe Davenport
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.5.6]
b. 23 Mar 1774 d. 5 Mar 1808
11
Seth Davenport
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.5.7]
b. 13 Jan 1775 d. 22 Apr 1843
11
Benjamin Davenport
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.5.8]
b. 10 Jul 1780 d. 14 Jul 1862
10
Matilda Daniels
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.6]
b. 16 Sep 1747
John Gould
b. Abt 1758
11
Mary Gould
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.6.1]
b. 1779 d. 27 May 1854
10
David Daniels
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.7]
b. 10 Nov 1749 d. 30 Apr 1811
+
Olive Adams
b. 1 Jan 1755 d. 16 Sep 1832
10
Huldah Daniels
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.8]
b. 6 Jan 1752 d. 26 Jun 1836
Silas Penniman
b. 20 Aug 1751 d. 12 May 1777
11
Scammell Penniman
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.8.1]
b. 12 Oct 1772
11
Rhene Penniman
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.8.2]
b. 27 Jan 1774
11
Amos Penniman
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.8.3]
b. 9 Oct 1775
11
Silas Penniman
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.8.4]
b. 12 Aug 1777 d. 1820
Henry Dearth
b. 6 Jun 1741 d. 24 Jun 1804
11
Ruth Dearth
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.8.5]
b. 13 Jul 1787
11
Irene Dearth
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.8.6]
b. 7 Apr 1789
11
June Dearth
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.8.7]
b. 7 Apr 1789
11
Leonard Dearth
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.8.8]
b. 30 Oct 1791 d. 3 Feb 1880
11
Mercy Dearth
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.8.9]
b. 10 Sep 1793
10
Moses Daniels
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.9]
b. 25 Feb 1753
Abigail Aldrich
b. 25 Feb 1761 d. 5 Jul 1834
11
Cyrena Daniels
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.9.1]
b. 26 Sep 1782
11
Salley Daniels
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.9.2]
b. 27 Nov 1784 d. 6 Sep 1842
11
Abigail Daniels
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.9.3]
b. 15 Nov 1786
11
Elbridge C Daniels
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.9.4]
b. 28 Nov 1788
11
Kelly Daniels
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.9.5]
b. 23 Sep 1791 d. 30 Dec 1839
10
Clotilda Daniels
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.10]
b. 19 Sep 1755 d. Abt 1813
Sherebiah Baker
b. 18 Mar 1747 d. May 1823
11
Marshal Baker
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.10.1]
b. 8 Nov 1774 d. 20 Oct 1848
11
Phila Baker
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.10.2]
b. 10 Jul 1773
11
Marshall Baker
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.10.3]
b. 1779
9
Priscilla Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.2]
b. 15 Aug 1721 d. Jan 1760
Moses Wood
b. 3 Apr 1712 d. Apr 1780
10
Mary Wood
[1.1.1.1.1.1.2.2.2.1]
b. 3 Mar 1740 d. 17 Apr 1841
10
Prissella Wood
[1.1.1.1.1.1.2.2.2.2]
b. 18 May 1741 d. 18 May 1741
10
Jerusha Wood
[1.1.1.1.1.1.2.2.2.3]
b. Abt 1744 d. 27 Apr 1790
10
Rachel Wood
[1.1.1.1.1.1.2.2.2.4]
b. 9 Jun 1746
10
Moses Wood
[1.1.1.1.1.1.2.2.2.5]
b. Abt 1748
10
Susanna Wood
[1.1.1.1.1.1.2.2.2.6]
b. Abt 1748
10
Daniel Wood
[1.1.1.1.1.1.2.2.2.7]
b. 10 Mar 1757
10
Hezekiah Wood
[1.1.1.1.1.1.2.2.2.8]
b. 14 Jan 1760 d. 26 May 1811
10
Rhoda Wood
[1.1.1.1.1.1.2.2.2.9]
b. 13 Apr 1762
9
Israel Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.3]
b. 23 Apr 1723 d. 1775
Martha Smith
b. 1722
10
Israel Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.3.1]
b. 12 Dec 1743
10
Amariah Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.3.2]
b. 18 Apr 1746 d. 1770
10
Oliver Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.3.3]
b. 4 Feb 1750
10
Elizabeth Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.3.4]
b. 27 Jul 1753
10
Marce Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.3.5]
b. 16 Jan 1757
9
Jacob Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4]
b. 22 Apr 1725 d. 15 Mar 1802
Esther Marsh
b. 28 Jun 1726 d. 14 Mar 1802
10
Esther Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.1]
b. 9 Jan 1747 d. 3 Feb 1834
James Taft
b. 9 Apr 1738 d. 14 Jan 1826
11
Lucy Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.1.1]
b. 22 Nov 1769 d. 29 Jul 1845
Ebenezer Winslow
b. 21 Jan 1772 d. 21 Feb 1841
12
Albert Winslow
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.1.1.1]
b. 24 Jul 1797 [
=>
]
12
Claramond Winslow
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.1.1.2]
b. 10 Feb 1799 d. 27 Apr 1834 [
=>
]
12
Alvin Winslow
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.1.1.3]
b. 27 Aug 1802 d. 9 Oct 1803
12
Paulina Maria Winslow
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.1.1.4]
b. 27 May 1805
12
Lucy Emma Winslow
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.1.1.5]
b. 17 Feb 1808 d. 20 Feb 1870
11
Zilpha Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.1.2]
b. 1 Jul 1772 d. 24 Feb 1848
Nathan Fisher
b. 25 Jun 1770 d. 21 Mar 1847
12
Elias Fisher
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.1.2.1]
b. 10 Jul 1796
12
Elise Fisher
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.1.2.2]
b. 10 Jul 1796
12
Josiah Fisher
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.1.2.3]
b. 26 Feb 1798 d. 11 Apr 1799
12
Josiah Fisher
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.1.2.4]
b. 1 Dec 1801
12
Rachel Adaline Fisher
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.1.2.5]
b. 29 Jan 1804
12
Mary Caroline Fisher
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.1.2.6]
b. 22 Mar 1806
12
Nathan Fisher
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.1.2.7]
b. 21 Mar 1811
11
Irena Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.1.3]
b. 25 Oct 1774 d. 29 May 1790
11
Ezekial Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.1.4]
b. 21 Jan 1777 d. 24 Apr 1841
+
Olive Thayer
b. 10 Aug 1782 d. 1865
11
James Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.1.5]
b. 13 Jun 1780
11
Luke Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.1.6]
b. 3 Jun 1783
Nancy Wood
b. 6 Feb 1787 d. 6 May 1859
12
Clarissa Wood Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.1.6.1]
b. 3 May 1810 d. 1889 [
=>
]
12
Moses Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.1.6.2]
b. 26 Jan 1812 [
=>
]
12
Sarah Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.1.6.3]
b. 15 Jan 1815 d. 24 Dec 1898 [
=>
]
12
Irene Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.1.6.4]
b. 19 Sep 1816 d. 26 Jan 1900 [
=>
]
12
Chloe M Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.1.6.5]
b. 5 Feb 1823 [
=>
]
12
James Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.1.6.6]
b. 1830
11
Esther Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.1.7]
b. 5 Aug 1786 d. 10 Aug 1858
Fuller Murdock
b. 17 Feb 1781 d. 8 Nov 1857
12
Philena Murdock
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.1.7.1]
b. 26 Aug 1807 d. 30 Jun 1835 [
=>
]
12
Abba Eliza Murdock
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.1.7.2]
b. 13 Nov 1808 d. 4 Apr 1834 [
=>
]
12
Moses Taft Murdock
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.1.7.3]
b. 12 Sep 1810 d. 7 Feb 1883 [
=>
]
12
John Murdock
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.1.7.4]
b. 9 Sep 1812 d. 13 Sep 1837
12
Charles Murdock
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.1.7.5]
b. 11 Feb 1815 d. 6 Aug 1869 [
=>
]
12
Caleb Murdock
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.1.7.6]
b. 16 Feb 1817 d. 10 May 1892 [
=>
]
12
George Taft Murdock
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.1.7.7]
b. 18 Mar 1819 [
=>
]
12
Harriet E. Murdock
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.1.7.8]
b. 6 Feb 1821 d. 30 Nov 1904 [
=>
]
12
Chapin Murdock
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.1.7.9]
b. 20 Jun 1823 d. 17 Sep 1882 [
=>
]
12
Mary Ann Murdock
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.1.7.10]
b. 18 Jun 1825 d. 27 Aug 1834
11
Moses Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.1.8]
b. 14 Jul 1788 d. 26 Jun 1810
11
Abigail Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.1.9]
b. 24 Jan 1791 d. 15 May 1837
Chandler Taft
b. 29 May 1792
12
Augustine Calvin Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.1.9.1]
b. 11 May 1817 [
=>
]
10
Timothy Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.2]
b. 3 Apr 1750 d. 30 Nov 1808
Priscilla Taft
b. 30 Apr 1749 d. 12 Sep 1833
11
Marcy Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.2.1]
b. 28 Sep 1771 d. 1 Aug 1848
+
Ezekiah Preston
b. Abt 1771
11
Josiah Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.2.2]
b. 3 May 1774
11
Abigail Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.2.3]
b. 14 Jan 1777 d. 17 Dec 1832
Moses Stone
b. 2 Mar 1775 d. 10 May 1803
12
Jonas Stone
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.2.3.1]
b. 6 Jun 1795 d. 30 Sep 1795
12
Sukey Stone
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.2.3.2]
b. 19 Feb 1798
11
Polly Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.2.4]
b. 1779 d. 5 Sep 1785
11
Timothy Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.2.5]
b. 1782 d. 5 Jan 1818
Mary "Polly" Reidel
b. 8 Feb 1784 d. 8 Feb 1863
12
Timothy Clark Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.2.5.1]
b. 21 Jul 1800 d. 11 May 1872 [
=>
]
12
Adolphus Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.2.5.2]
b. Abt 1804
12
Harry Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.2.5.3]
b. Abt 1806
12
Ezekiel Preston Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.2.5.4]
b. Abt 1807
12
Washington Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.2.5.5]
b. Abt 1808 d. Abt 1823
12
Charlotte Clark Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.2.5.6]
b. Abt 1810
12
Christine Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.2.5.7]
b. 1811 d. 8 Jul 1847
12
Jacob R Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.2.5.8]
b. 29 Oct 1814 d. 1 Jan 1875
11
Joseph Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.2.6]
b. 1784
11
Jonas Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.2.7]
b. 1786
11
Polly Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.2.8]
b. 1788 d. 1859
10
Jacob Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.3]
b. 1 Dec 1751 d. 30 May 1823
Mary Taft
b. 14 Feb 1753 d. 19 Jul 1832
11
Lois Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.3.1]
b. 27 Aug 1780 d. 27 Apr 1854
Josiah Seagrave
b. 14 Oct 1773 d. 20 Mar 1855
12
Mary Ann Seagrave
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.3.1.1]
b. 17 Nov 1799 d. 10 Feb 1825
12
Jacob Taft Seagraves
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.3.1.2]
b. 8 Apr 1802 d. 24 Sep 1870
12
Henrietta Frost Seagrave
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.3.1.3]
b. 1 Dec 1803 d. 1 Jun 1823
12
Waity Grant Seagrave
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.3.1.4]
b. 23 Sep 1805 d. 27 Jan 1859
12
Edward Seagrave
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.3.1.5]
b. 3 Sep 1807 d. 15 Feb 1873
12
Lois Taft Seagrave
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.3.1.6]
b. 13 Apr 1809 d. 19 Mar 1853
12
Josiah Seagrave, Jr
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.3.1.7]
b. 24 May 1811 d. 21 Jul 1861
12
Malvina Seagrave
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.3.1.8]
b. 2 Apr 1813 d. 16 Dec 1823
12
Caleb Seagrave
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.3.1.9]
b. 8 Feb 1815 d. 14 Nov 1823
12
Son Seagrave
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.3.1.10]
b. 3 May 1817 d. 3 May 1817
12
Daughter Seagrave
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.3.1.11]
b. 3 May 1817 d. 3 May 1817
12
Esborn Seagrave
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.3.1.12]
b. 28 Dec 1818 d. 27 Oct 1856
12
George Augustus Seagrave
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.3.1.13]
b. 6 Jan 1823 d. 15 Nov 1884
11
Hannah Margaret Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.3.2]
b. 28 Nov 1782 d. 2 Apr 1857
Stephen Carpenter
b. 13 Aug 1778 d. 1 Oct 1854
12
Eunice Carpenter
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.3.2.1]
b. Sep 1802 d. Mar 1864
12
Orsmus T Carpenter
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.3.2.2]
b. Jan 1805 d. 4 Apr 1863
12
Joseph Rawson Carpenter
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.3.2.3]
b. 2 Apr 1807 d. May 1839
12
Charlotte Taft Carpenter
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.3.2.4]
b. 4 Feb 1809 d. 5 Sep 1845
12
Charles A Carpenter
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.3.2.5]
b. 11 Feb 1813 d. 12 Aug 1887
12
Mary T Carpenter
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.3.2.6]
b. 1815
12
Hannah Taft Carpenter
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.3.2.7]
b. 20 Aug 1817 d. 17 Dec 1890
12
Nancy Carter Carpenter
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.3.2.8]
b. 5 Jun 1820 d. 15 May 1898
12
Henrietta Carpenter
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.3.2.9]
b. Apr 1823 d. Feb 1847
12
George Carpenter
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.3.2.10]
b. 13 Jan 1825
11
Elisabeth Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.3.3]
b. 8 Nov 1784
Ephraim Taft
b. 18 Aug 1780
12
Mary Ann Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.3.3.1]
b. 22 May 1805
12
Ephriam Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.3.3.2]
b. 8 Feb 1807
11
Mary Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.3.4]
b. 16 Mar 1786 d. 25 Feb 1860
11
Charlotte Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.3.5]
b. 25 Feb 1789
11
John Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.3.6]
b. 3 Dec 1792 d. 29 May 1826
Lucretia Newell
b. 24 Sep 1795 d. 29 Dec 1863
12
Robert Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.3.6.1]
b. 27 May 1819
12
Jacob Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.3.6.2]
b. 19 May 1823
11
Orsmus Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.3.7]
b. 1 Jan 1795
10
Abigail Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.4]
b. 5 Oct 1754 d. 12 Aug 1775
Barzillai Taft
b. 3 Nov 1750 d. 21 Jan 1839
11
Eunice Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.4.1]
b. 28 Jan 1775 d. 30 May 1861
Phineas Chapin
b. 3 Aug 1769 d. 3 May 1839
12
Abby Chapin
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.4.1.1]
b. 1 Feb 1796
12
Laurinda Chapin
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.4.1.2]
b. 6 Feb 1798 d. 20 Dec 1866
12
Sarah Richardson Chapin
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.4.1.3]
b. 30 Apr 1800 d. 16 Apr 1884
12
Chloe T Chapin
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.4.1.4]
b. 8 Apr 1802 d. 5 Oct 1881
12
Mary Warren Chapin
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.4.1.5]
b. 27 Feb 1804 d. 13 Nov 1890
12
Caleb Chapin
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.4.1.6]
b. 6 Feb 1806 d. 27 Sep 1883 [
=>
]
12
Margaret Ann Chapin
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.4.1.7]
b. 16 Jun 1808 d. 15 Nov 1897
12
Bezaileel Taft Chapin
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.4.1.8]
b. 21 Oct 1810 d. 28 May 1855
12
Samuel Judson Chapin
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.4.1.9]
b. 27 Aug 1812 d. 18 Nov 1908
12
Son Chapin
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.4.1.10]
b. 15 Oct 1815
12
Gardner Spring Chapin
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.4.1.11]
b. 2 Oct 1817 d. 4 Aug 1892
12
Josiah Spring Chapin
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.4.1.12]
b. 24 Aug 1820 d. 26 Dec 1882
10
Lois Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.5]
b. 28 Apr 1757 d. 10 Feb 1792
Caleb Farnum
b. 9 Nov 1753 d. 3 Jan 1829
11
Royal Farnham
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.5.1]
b. 28 Nov 1775 d. 3 Sep 1845
+
Betsey Whitney
b. 29 Jul 1779
11
Easman Farnum
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.5.2]
b. 22 Dec 1777
Rebecca Chamberlain
b. 10 Feb 1778
12
Almira Farnum
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.5.2.1]
b. 1801 d. 24 Jan 1829
12
George V R Farnham
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.5.2.2]
b. 12 Sep 1812 d. 3 Jul 1871 [
=>
]
11
Caleb Farnum
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.5.3]
b. 15 Jul 1781 d. 16 Jun 1863
Silvania Allen
b. 5 Mar 1782 d. 13 Oct 1846
12
Elizabeth F Farnham
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.5.3.1]
b. 21 Apr 1805 d. 20 Jul 1827 [
=>
]
12
George A Farnham
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.5.3.2]
b. 27 Jun 1807
12
Clarissa Taft Farnum
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.5.3.3]
b. 27 Jun 1807 d. 26 Oct 1839
12
Edward Judson Farnham
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.5.3.4]
b. 16 Mar 1809 d. 11 Jul 1894 [
=>
]
12
Caroline Farnum
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.5.3.5]
b. 13 Aug 1810 d. 26 Aug 1810
12
Carleton Lee Farnham
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.5.3.6]
b. 13 Jul 1811 [
=>
]
12
William A Farnham
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.5.3.7]
b. 13 Mar 1813 d. 28 Feb 1814
12
William A Farnham
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.5.3.8]
b. 13 Aug 1815 d. 2 Aug 1860
12
Dorcas Adelaide Farnum
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.5.3.9]
b. 9 Jun 1820 d. 13 Aug 1842
12
Mary Frances Farnham
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.5.3.10]
b. 29 Jul 1823 d. 1 Jan 1847
+
Sally Jones
b. 1783 d. 12 May 1874
11
Clarissa Farnam
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.5.4]
b. 22 Aug 1784
+
Elihu Morgan
b. 1780
10
Mercy Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.6]
b. 5 Mar 1758 d. 18 Feb 1843
Otis Russell
b. 9 Dec 1733
11
Meribah Russell
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.6.1]
b. 1805 d. Aft 1860
10
Israel Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.7]
b. 1 Mar 1761 d. 24 Apr 1842
Submit Read
b. 21 Jun 1763 d. 17 May 1841
11
Ruth Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.7.1]
b. 5 Jan 1783
Benjamin Farrow
b. 9 Mar 1782 d. 17 Oct 1861
12
Drucilla Farrow
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.7.1.1]
b. 10 Apr 1805 d. 7 Nov 1896
12
Theodore Grey Farrow
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.7.1.2]
b. 25 Feb 1807 d. 23 Jan 1907
12
Submit Farrow
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.7.1.3]
b. 4 Jan 1809 d. 22 Nov 1882
12
Cecelia Farrow
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.7.1.4]
b. 26 May 1810 d. 18 Jul 1835
12
Israel Taft Farrow
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.7.1.5]
b. 25 May 1812 d. 23 Apr 1903
12
Franklin Farrow
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.7.1.6]
b. 31 Aug 1813 d. 3 Feb 1892
12
Independence Farrow
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.7.1.7]
b. 4 Jul 1815 d. 7 Sep 1891
12
Constantine Farrow
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.7.1.8]
b. 11 Mar 1817 d. 28 Feb 1871
12
Lucy Farrow
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.7.1.9]
b. 13 Oct 1819 d. 12 Jul 1850
12
Benjamin Farrow
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.7.1.10]
b. 13 Oct 1819 d. 17 Oct 1819
12
Caleb Walter Farrow
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.7.1.11]
b. 16 Jan 1823 d. 26 Jul 1860
12
Emeline Farrow
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.7.1.12]
b. 16 Jun 1824 d. 30 Aug 1842
12
Miranda Farrow
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.7.1.13]
b. 5 Jul 1827 d. 2 Feb 1877
11
Clarisa Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.7.2]
b. 5 Mar 1786
11
Elzaphan Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.7.3]
b. 15 Feb 1788 d. 23 Mar 1847
Elisabeth Fowler
b. 1791 d. 30 Sep 1871
12
Gilbert Chase Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.7.3.1]
b. 22 Nov 1813
12
Emila Angenett Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.7.3.2]
b. 15 Sep 1815
12
Samuel Read Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.7.3.3]
b. 6 Aug 1818 d. 30 Aug 1835
12
John E Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.7.3.4]
b. 25 Feb 1821
12
Cyrus Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.7.3.5]
b. 27 Nov 1824 d. 6 Feb 1832
12
Lucinda M Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.7.3.6]
b. 26 Jul 1827
12
Elizabeth G. Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.7.3.7]
b. 17 May 1833
11
Abigail Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.7.4]
b. 9 Feb 1790 d. 5 Jun 1791
11
Laurana Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.7.5]
b. 13 May 1792
Cheany Taft
b. 8 Dec 1787 d. 13 Feb 1840
12
Caleb Walter Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.7.5.1]
b. 11 Oct 1813 d. 19 Dec 1813
12
Henry Cheney Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.7.5.2]
b. 20 Apr 1815
11
Lydia Mariah Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.7.6]
b. 10 Jul 1794
Washington White
b. 17 May 1796
12
Ruth Taft White
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.7.6.1]
b. 16 Jun 1819
12
Sarah Ann White
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.7.6.2]
b. 17 Sep 1821
12
Lurana Taft White
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.7.6.3]
b. 14 Apr 1823
12
Lydia Mariah White
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.7.6.4]
b. 3 Apr 1825
12
Eunice Fletcher White
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.7.6.5]
b. 1 Jan 1827
12
Mary Elizabeth White
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.7.6.6]
b. 15 Sep 1829
12
Margaret B White
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.7.6.7]
b. 20 Jul 1833
12
Caroline Frances White
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.7.6.8]
b. 20 Jan 1835
12
Henry Kirk White
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.7.6.9]
b. 10 May 1837
12
William Edwards White
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.7.6.10]
b. 8 Mar 1839
12
Lucy B White
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.7.6.11]
b. 16 Oct 1841
12
Emma Jane White
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.7.6.12]
b. 18 Feb 1845
11
Cyrus Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.7.7]
b. 3 Feb 1797
Lucinda Morse
b. 1800 d. 25 Jul 1860
12
Gustavus Elzaphan Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.7.7.1]
b. 29 Aug 1829 d. 23 Jun 1888
12
Son Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.7.7.2]
b. 1831
12
Peter Morse Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.7.7.3]
b. 1833
12
Edmond M Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.7.7.4]
b. 1834 d. 25 Oct 1858
11
Louis Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.7.8]
b. 25 Apr 1801
10
Eastman Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.8]
b. 16 Jun 1763 d. 29 Apr 1829
Chloa Taft
b. 25 Nov 1763 d. 4 May 1783
11
Eastman Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.8.1]
b. 2 May 1783 d. 8 Aug 1857
Hannah Taft
b. 1 Nov 1763 d. 3 Jul 1832
11
Chloe Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.8.2]
b. 7 Jul 1785 d. 25 Apr 1826
John Perry Benson
b. 22 Jul 1781 d. 21 Jan 1842
12
Charlotte Taft Benson
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.1]
b. 30 Sep 1807 d. 16 Jul 1878 [
=>
]
12
Ezra Taft Benson
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.2]
b. 22 Feb 1811 d. 3 Sep 1869 [
=>
]
12
George Taft Benson
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.3]
b. Abt 1813 [
=>
]
12
Hannah Benson
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.4]
b. 18 Sep 1816 [
=>
]
12
Abbie Ann Benson
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.5]
b. Abt 1809 d. 21 Sep 1883 [
=>
]
12
John M Benson
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.6]
b. 1819 d. 12 Aug 1829
11
Ezra Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.8.3]
b. 6 Mar 1793 d. 19 Feb 1808
9
Hannah Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.5]
b. 16 Nov 1726 d. 15 Mar 1802
Elijah Clarke Benjamin
b. 8 Jun 1725 d. 1768
10
Elias Benjamin
[1.1.1.1.1.1.2.2.5.1]
b. 4 May 1750 d. 8 Apr 1823
Rhoda Paddock
b. 9 Sep 1785 d. 5 Jun 1858
11
Deborah Benjamin
[1.1.1.1.1.1.2.2.5.1.1]
b. 25 Apr 1803 d. 6 Dec 1871
11
Ezra H. Benjamin
[1.1.1.1.1.1.2.2.5.1.2]
b. 21 May 1804 d. 20 Jul 1876
11
Edmund Benjamin
[1.1.1.1.1.1.2.2.5.1.3]
b. 28 Jan 1806 d. 25 Nov 1887
11
Robert L Benjamin
[1.1.1.1.1.1.2.2.5.1.4]
b. 14 Jun 1808 d. 20 Jul 1892
11
Hannah Almedia Benjamin
[1.1.1.1.1.1.2.2.5.1.5]
b. 29 Sep 1810 d. Abt 1870
11
John Mills Benjamin
[1.1.1.1.1.1.2.2.5.1.6]
b. 5 Jun 1813 d. 1849
11
Isaac Paddock Benjamin
[1.1.1.1.1.1.2.2.5.1.7]
b. 21 Jul 1815 d. 5 Apr 1892
11
Mary E Benjamin
[1.1.1.1.1.1.2.2.5.1.8]
b. 1 Sep 1817 d. 3 Dec 1819
11
William F Benjamin
[1.1.1.1.1.1.2.2.5.1.9]
b. 18 Apr 1820 d. 10 Aug 1869
11
David E Benjamin
[1.1.1.1.1.1.2.2.5.1.10]
b. 1 May 1822 d. 25 Aug 1890
11
Mary Elizabeth Benjamin
[1.1.1.1.1.1.2.2.5.1.11]
b. 24 Jun 1824 d. 2 Oct 1894
11
Sidney S Benjamin
[1.1.1.1.1.1.2.2.5.1.12]
b. 19 Jul 1826 d. 7 May 1862
11
Jane Ann Benjamin
[1.1.1.1.1.1.2.2.5.1.13]
b. 7 Dec 1829 d. 29 Mar 1915
10
Chester Benjamin
[1.1.1.1.1.1.2.2.5.2]
b. 9 Feb 1751 d. 1830
10
William Benjamin
[1.1.1.1.1.1.2.2.5.3]
b. 6 Mar 1753
10
Captain Elijah Taft Benjamin
[1.1.1.1.1.1.2.2.5.4]
b. 27 Dec 1755 d. 17 Jun 1819
Elizabeth Paddock
b. 1 Nov 1762 d. 26 Apr 1822
11
Elias Paddock Benjamin
[1.1.1.1.1.1.2.2.5.4.1]
b. 6 May 1783 d. 27 Nov 1866
11
David Benjamin
[1.1.1.1.1.1.2.2.5.4.2]
b. 18 May 1785 d. 18 Feb 1825
11
Elijah E Benjamin
[1.1.1.1.1.1.2.2.5.4.3]
b. 26 Oct 1788 d. 19 May 1880
11
Charles Benjamin
[1.1.1.1.1.1.2.2.5.4.4]
b. 7 Oct 1789 d. 10 Feb 1874
11
Daughter Benjamin
[1.1.1.1.1.1.2.2.5.4.5]
b. 1791
11
Frederick B Benjamin
[1.1.1.1.1.1.2.2.5.4.6]
b. 1794 d. 1868
11
Aaron Benjamin
[1.1.1.1.1.1.2.2.5.4.7]
b. 1801 d. 4 Feb 1883
11
Loretta Benjamin
[1.1.1.1.1.1.2.2.5.4.8]
b. 5 Feb 1804 d. 8 Feb 1886
10
Cyrus Benjamin
[1.1.1.1.1.1.2.2.5.5]
b. 7 Jul 1762 d. 19 Jul 1817
Rhoda Maria Dibble
b. 7 Oct 1771 d. 8 Dec 1817
11
Mary Crosby Benjamin
[1.1.1.1.1.1.2.2.5.5.1]
b. 11 Oct 1790
11
Hannah Benjamin
[1.1.1.1.1.1.2.2.5.5.2]
b. 2 Jan 1792 d. 1 Jan 1794
11
David C Benjamin
[1.1.1.1.1.1.2.2.5.5.3]
b. 7 Nov 1793
11
Anna Benjamin
[1.1.1.1.1.1.2.2.5.5.4]
b. 22 Jan 1796 d. 9 Oct 1817
11
Annis Benjamin
[1.1.1.1.1.1.2.2.5.5.5]
b. 10 Feb 1798 d. 16 Jun 1869
11
Peter Benjamin
[1.1.1.1.1.1.2.2.5.5.6]
b. 14 Feb 1800 d. 2 Sep 1839
11
Cyrus Benjamin
[1.1.1.1.1.1.2.2.5.5.7]
b. 11 Jul 1801
11
Nathaniel Benjamin
[1.1.1.1.1.1.2.2.5.5.8]
b. 23 Jun 1803
11
Charles J Benjamin
[1.1.1.1.1.1.2.2.5.5.9]
b. 17 Feb 1805 d. 1877
11
Elijah Benjamin
[1.1.1.1.1.1.2.2.5.5.10]
b. 28 May 1807
11
Eliza "Wealthy" Benjamin
[1.1.1.1.1.1.2.2.5.5.11]
b. 28 May 1807 d. 28 Jan 1862
11
Joel Samuel Benjamin
[1.1.1.1.1.1.2.2.5.5.12]
b. 17 Apr 1809 d. 4 Feb 1882
11
Catherine E Benjamin
[1.1.1.1.1.1.2.2.5.5.13]
b. 18 Jan 1814
11
Cyrus S Benjamin
[1.1.1.1.1.1.2.2.5.5.14]
b. 13 Jun 1816
11
Daniel W Benjamin
[1.1.1.1.1.1.2.2.5.5.15]
b. 13 Jun 1816 d. 2 Jun 1892
10
Hannah Benjamin
[1.1.1.1.1.1.2.2.5.6]
b. 7 Jul 1762 d. 13 May 1840
10
Mary Benjamin
[1.1.1.1.1.1.2.2.5.7]
b. 7 Jul 1768 d. 5 Feb 1849
10
Darius Benjamin
[1.1.1.1.1.1.2.2.5.8]
b. 17 Jan 1758 d. 12 Feb 1850
9
Elisha Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.6]
b. 3 May 1728 d. 3 Mar 1791
Experience Taft
b. 7 Apr 1733 d. 15 Mar 1817
10
Hannah Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.6.1]
b. 16 Mar 1758
10
Elisha Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.6.2]
b. 4 Mar 1761 d. 16 Jan 1820
Mary Sadler
b. 15 Aug 1768 d. 1800
11
Hiram Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.6.2.1]
b. 2 Apr 1789 d. 15 Nov 1794
11
Elisha Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.6.2.2]
b. 23 Jul 1791 d. 26 Feb 1858
11
Ormon Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.6.2.3]
b. 11 Nov 1793 d. 23 Jan 1794
11
Mary Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.6.2.4]
b. 23 May 1795 d. 23 Feb 1875
10
Sarah Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.6.3]
b. 21 Mar 1763 d. 11 Oct 1835
Ezra Wood, Jr
b. 12 Mar 1759 d. 10 May 1837
11
Ezra Wood
[1.1.1.1.1.1.2.2.6.3.1]
b. 25 Oct 1781
11
Experience Wood
[1.1.1.1.1.1.2.2.6.3.2]
b. 16 Mar 1783 d. 14 Oct 1818
11
Sarah Wood
[1.1.1.1.1.1.2.2.6.3.3]
b. 7 Aug 1784
11
Elisha Wood
[1.1.1.1.1.1.2.2.6.3.4]
b. 24 Apr 1786 d. 19 Oct 1797
11
Jonathan Wood
[1.1.1.1.1.1.2.2.6.3.5]
b. 8 Oct 1787 d. 26 Feb 1846
11
Anna Wood
[1.1.1.1.1.1.2.2.6.3.6]
b. 31 Aug 1789 d. 20 Mar 1832
11
Chapin Wood
[1.1.1.1.1.1.2.2.6.3.7]
b. 2 Apr 1792
11
Lucy Wood
[1.1.1.1.1.1.2.2.6.3.8]
b. 11 Nov 1794 d. 10 Dec 1826
11
Silva Wood
[1.1.1.1.1.1.2.2.6.3.9]
b. 29 Apr 1796
11
Silva Wood
[1.1.1.1.1.1.2.2.6.3.10]
b. 29 Apr 1796
11
Phila Wood
[1.1.1.1.1.1.2.2.6.3.11]
b. 5 Jul 1798
11
Elisha Wood
[1.1.1.1.1.1.2.2.6.3.12]
b. 7 Nov 1800
11
Simeon Wood
[1.1.1.1.1.1.2.2.6.3.13]
b. 5 Jan 1805
10
Israel Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.6.4]
b. 12 Feb 1766
10
Joseph Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.6.5]
b. 15 Sep 1768 d. Aft 29 Sep 1815
Sarah Farrar
b. 14 Sep 1764 d. 5 Aug 1810
11
Experience
[1.1.1.1.1.1.2.2.6.5.1]
b. 5 Feb 1792
11
Amiel F Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.6.5.2]
b. 1 Oct 1794 d. 29 Nov 1869
11
Roxalana Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.6.5.3]
b. 22 Jan 1798
11
Sofrona Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.6.5.4]
b. 17 Jun 1800
11
Esquire Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.6.5.5]
b. 28 Apr 1803 d. 11 Mar 1865
11
Deborah R Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.6.5.6]
b. 6 Jan 1806
+
Marcy Stockwell
b. Abt 1794
9
Mercy Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.7]
b. 7 Apr 1733 d. 27 Mar 1801
Benjamin Green
b. 11 Aug 1734 d. 16 Aug 1797
10
Benjamin Green
[1.1.1.1.1.1.2.2.7.1]
b. 6 Jan 1754
10
Israel Green
[1.1.1.1.1.1.2.2.7.2]
b. 22 Jun 1755
10
Margery Green
[1.1.1.1.1.1.2.2.7.3]
b. 1 Feb 1758 d. 22 Sep 1838
Josiah Taft
b. 28 Oct 1752 d. 8 Jan 1846
11
Josiah Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.7.3.1]
b. 10 Apr 1778 d. 30 Dec 1790
11
Lydia Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.7.3.2]
b. 13 Feb 1780
11
Israel Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.7.3.3]
b. 30 Jul 1782 d. 10 Apr 1840
Ann Taft
b. 23 Aug 1791 d. 17 Dec 1821
12
Julia Ann Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.7.3.3.1]
b. 15 Apr 1810
12
Marcy Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.7.3.3.2]
b. 2 Jun 1812
11
Benjamin Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.7.3.4]
b. 3 Aug 1784 d. 13 May 1863
11
Mercy Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.7.3.5]
b. 1786 d. 12 Jun 1803
11
Polly Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.7.3.6]
b. 23 Sep 1790
11
Andre Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.7.3.7]
b. 25 Jun 1792 d. 26 Jun 1850
Sarah Williams Baker
b. 8 Feb 1796
12
Margary Ann Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.7.3.7.1]
b. 4 May 1818 d. 4 Nov 1904 [
=>
]
12
Caroline Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.7.3.7.2]
b. 21 Aug 1821 d. 7 Nov 1907 [
=>
]
11
Judson Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.7.3.8]
b. 14 Feb 1793 d. 26 Jan 1891
11
Eunice Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.7.3.9]
b. 14 Mar 1795
11
Harry Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.7.3.10]
b. 5 Mar 1797
11
Guilford Hodges Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.7.3.11]
b. 1 Jan 1799 d. 22 Nov 1816
10
Marcy Green
[1.1.1.1.1.1.2.2.7.4]
b. 1 Jan 1760 d. 8 Jun 1815
Cummings Taft
b. 27 Aug 1770 d. 22 Jun 1841
11
Ezra Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.7.4.1]
b. 13 May 1797 d. 16 Nov 1878
Mercy G White
b. 1796 d. 14 Mar 1822
12
Austin Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.7.4.1.1]
b. 1 Mar 1822 d. 4 Sep 1844
Susanna Keith
b. 3 Jan 1801
12
Laura Ann M Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.7.4.1.2]
b. 26 Jun 1824 d. 26 May 1855 [
=>
]
12
Lucinda M Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.7.4.1.3]
b. 15 Mar 1826 d. 5 Mar 1906 [
=>
]
12
Artemas K Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.7.4.1.4]
b. 24 May 1828 d. 27 Dec 1878 [
=>
]
12
Uranah Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.7.4.1.5]
b. 25 Jan 1831
12
Daines C Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.7.4.1.6]
b. 1835 [
=>
]
12
Susan A Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.7.4.1.7]
b. 1838
12
Hannah Jane Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.7.4.1.8]
b. 17 Nov 1839 d. 7 Jan 1848
11
Benjamin Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.7.4.2]
b. 10 Aug 1798 d. 29 May 1799
11
Benjamin Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.7.4.3]
b. 6 May 1800 d. 17 Oct 1828
Martha Bethsheba White
b. 1803
12
Benjamin Lorin Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.7.4.3.1]
b. 25 Jun 1823
12
Russell White Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.7.4.3.2]
b. 23 Jan 1826 d. 4 Dec 1868
11
Hannah G Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.7.4.4]
b. 18 May 1802 d. 8 Jan 1843
Newell Taft
b. 28 Jul 1804 d. 4 Nov 1873
12
Albert Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.7.4.4.1]
b. 28 Aug 1823 d. Aft 1874 [
=>
]
12
Marcy Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.7.4.4.2]
b. Mar 1829 d. 12 Apr 1830
12
Charles M Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.7.4.4.3]
b. Jan 1843 d. 7 Dec 1843
10
Hannah Green
[1.1.1.1.1.1.2.2.7.5]
b. 2 Apr 1763
10
Rachel Green
[1.1.1.1.1.1.2.2.7.6]
b. 27 Aug 1765
10
Samuel Green
[1.1.1.1.1.1.2.2.7.7]
b. 14 Mar 1767
9
Stephen Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.8]
b. 21 Aug 1734 d. 3 Feb 1803
Anna Taft
b. 14 Apr 1748 d. 3 Apr 1830
10
Lydia Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.8.1]
b. 13 Oct 1766 d. 13 Jan 1847
10
Hazeltine Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.8.2]
b. 6 Jan 1769 d. 18 Jul 1856
10
Gravenor Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.8.3]
b. 1773 d. 1838
10
Marcy Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.8.4]
b. 5 Sep 1775
10
Ephraim Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.8.5]
b. 18 Aug 1780
Elisabeth Taft
b. 8 Nov 1784
11
Mary Ann Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.8.5.1]
b. 22 May 1805
11
Ephriam Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.8.5.2]
b. 8 Feb 1807
10
Lovice Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.8.6]
b. 1 Jul 1783
10
Anna Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.8.7]
b. 29 Nov 1784
10
Stephen Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.8.8]
b. 12 Dec 1787
10
Adolphas Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.8.9]
b. 2 Oct 1791
9
Samuel Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.9]
b. 23 Sep 1735 d. 2 Aug 1816
Mary Murdock
b. 3 Jan 1742 d. 26 Mar 1785
10
Frederick Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.9.1]
b. 19 Jun 1759 d. 10 Feb 1846
Abigail Wood
b. 29 Aug 1761 d. 2 Jun 1851
11
Samuel Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.9.1.1]
b. 12 Dec 1782 d. 8 Feb 1842
11
Murdock Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.9.1.2]
b. 8 Dec 1784 d. 6 Aug 1820
11
Calista Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.9.1.3]
b. 31 Jan 1787 d. 11 Dec 1864
11
Clarinda Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.9.1.4]
b. 28 Feb 1789 d. 11 Apr 1877
Cabel Mowry
b. Abt 1783 d. 16 May 1845
12
Emily M Mowry
[1.1.1.1.1.1.2.2.9.1.4.1]
b. 13 Oct 1814 d. 25 May 1880 [
=>
]
12
Decatur Mowrey
[1.1.1.1.1.1.2.2.9.1.4.2]
b. 30 Sep 1816 d. 31 Jul 1856
12
Bainbridge Mowry
[1.1.1.1.1.1.2.2.9.1.4.3]
b. 23 Jul 1818 d. 1893
12
Albert Mowry
[1.1.1.1.1.1.2.2.9.1.4.4]
b. 20 Apr 1822 d. 30 Mar 1900
12
Reuben Ransom Mowrey
[1.1.1.1.1.1.2.2.9.1.4.5]
b. 5 Apr 1826
12
Anna Ransom Mowry
[1.1.1.1.1.1.2.2.9.1.4.6]
b. 13 Sep 1827 d. 15 Jan 1903
12
Wesley Mowry
[1.1.1.1.1.1.2.2.9.1.4.7]
b. 26 May 1830 d. 11 Aug 1833
11
Frederic A Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.9.1.5]
b. 7 Apr 1790 d. 18 Sep 1837
11
Nabby Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.9.1.6]
b. 7 Jun 1793 d. 19 Jul 1880
11
Harriet Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.9.1.7]
b. 25 Jul 1795 d. 3 Sep 1852
11
Parla Parilla Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.9.1.8]
b. 5 Mar 1798 d. 26 Sep 1852
11
Ezra Wood Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.9.1.9]
b. 26 Aug 1800 d. 8 Feb 1885
11
Mary Ann Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.9.1.10]
b. 11 Sep 1803 d. 7 Sep 1850
11
Margaret Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.9.1.11]
b. 31 May 1806 d. 23 Jan 1891
10
Sibbel Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.9.2]
b. 19 Aug 1760 d. 28 Sep 1761
10
Lyman Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.9.3]
b. 14 Mar 1762 d. 24 Jul 1833
10
Mercy Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.9.4]
b. 23 Apr 1765 d. 25 Apr 1768
10
Willard Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.9.5]
b. 30 Oct 1766 d. 14 Sep 1845
10
Parley Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.9.6]
b. 20 Jan 1768 d. 13 Apr 1768
10
Merret Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.9.7]
b. 26 Jan 1769
10
Otis Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.9.8]
b. 29 Oct 1771
10
Farla Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.9.9]
b. 24 Mar 1774 d. 6 Apr 1864
10
Washington Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.9.10]
b. 16 Sep 1775
10
Philena Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.9.11]
b. 11 Mar 1781 d. 1814
10
George Washington Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.9.12]
b. 1 May 1783 d. 30 Nov 1824
Experiance Humes
b. 27 May 1750 d. 15 Jan 1837
10
Dandridge Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.9.13]
b. 1 Aug 1787 d. 10 Aug 1832
10
Warner Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.9.14]
b. 15 Sep 1789 d. 3 Aug 1837
10
Experiance Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.9.15]
b. 10 Jun 1791 d. 30 Nov 1863
10
Polley Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.9.16]
b. 18 Mar 1794
9
Margery Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.10]
b. 14 May 1738 d. 20 Jan 1813
Simeon Wood
b. 7 Jan 1732 d. 11 May 1802
10
Stephen Wood
[1.1.1.1.1.1.2.2.10.1]
b. 14 Oct 1761 d. Abt 1820
10
Simeon Wood, Jr
[1.1.1.1.1.1.2.2.10.2]
b. 14 Oct 1761 d. 1819
10
Rhoda Wood
[1.1.1.1.1.1.2.2.10.3]
b. 25 May 1763 d. 8 Apr 1832
10
Jerusha Wood
[1.1.1.1.1.1.2.2.10.4]
b. 28 Jun 1765 d. 8 Apr 1832
Asa Newell
b. 27 Nov 1761 d. 4 Aug 1808
11
Caleb Newell
[1.1.1.1.1.1.2.2.10.4.1]
b. Abt 1786
11
Eabon Carter Newell
[1.1.1.1.1.1.2.2.10.4.2]
b. 17 Nov 1788 d. 3 Mar 1831
11
Matilda Newell
[1.1.1.1.1.1.2.2.10.4.3]
b. 1793 d. 28 Aug 1830
11
Lucretia Newell
[1.1.1.1.1.1.2.2.10.4.4]
b. 24 Sep 1795 d. 29 Dec 1863
John Taft
b. 3 Dec 1792 d. 29 May 1826
12
Robert Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.10.4.4.1]
b. 27 May 1819
12
Jacob Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.10.4.4.2]
b. 19 May 1823
11
Jerusha Newell
[1.1.1.1.1.1.2.2.10.4.5]
b. 7 Nov 1799 d. 31 Oct 1879
11
Asa Newell
[1.1.1.1.1.1.2.2.10.4.6]
b. 31 Aug 1803 d. Apr 1865
10
Caleb Wood
[1.1.1.1.1.1.2.2.10.5]
b. 2 Jun 1767 d. 24 Jun 1769
10
Willis Wood
[1.1.1.1.1.1.2.2.10.6]
b. 14 Jul 1769 d. 5 Oct 1779
10
Nathaniel G Wood
[1.1.1.1.1.1.2.2.10.7]
b. 24 Jul 1771 d. 4 Sep 1847
10
Lois Wood
[1.1.1.1.1.1.2.2.10.8]
b. 8 Nov 1772 d. 20 Apr 1773
10
Eunice Wood
[1.1.1.1.1.1.2.2.10.9]
b. 11 Apr 1773 d. 28 Jun 1791
10
Jesse Wood
[1.1.1.1.1.1.2.2.10.10]
b. 29 Aug 1775 d. Bef 1884
10
Mary Wood
[1.1.1.1.1.1.2.2.10.11]
b. 3 Jan 1778 d. 3 Jan 1868
10
Sibel Wood
[1.1.1.1.1.1.2.2.10.12]
b. 12 Jan 1781 d. Feb 1831
9
Silas Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.11]
b. 17 Dec 1739 d. 10 May 1741
9
Rachel Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.12]
b. 18 Jul 1742 d. 30 Dec 1747
9
Silas Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.13]
b. 5 Nov 1744
Elizabeth Sadler
b. 13 Sep 1754
10
Stephen Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.13.1]
b. 22 Feb 1773 d. 26 Oct 1846
10
Silas Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.13.2]
b. 2 Jun 1775
10
Israel Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.13.3]
b. 22 Sep 1777 d. 19 May 1842
10
Joel Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.13.4]
b. 28 Apr 1780
10
Belzaleel Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.13.5]
b. 28 Jan 1783 d. 15 Apr 1831
10
Otis Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.13.6]
b. 17 Sep 1786 d. 19 Nov 1827
Thankful Benson
b. 29 Aug 1783 d. 11 Apr 1808
11
Tilus Vespasian Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.13.6.1]
b. 4 Jun 1806 d. 22 Feb 1889
Sarah Jane Hagar
b. 16 Dec 1810 d. 25 Sep 1852
12
Louis V Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.13.6.1.1]
b. 2 Oct 1831
12
Abby Jane Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.13.6.1.2]
b. 30 Oct 1836 d. 1906
12
Georgiana Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.13.6.1.3]
b. 31 Mar 1839 d. 9 Oct 1918
12
James K Polk Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.13.6.1.4]
b. 17 May 1847 d. 15 Sep 1847
12
Sarah Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.13.6.1.5]
b. 21 Sep 1852 d. 21 Sep 1852
Katharine Edwards
b. 22 Dec 1815 d. 22 Feb 1878
12
Henry Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.13.6.1.6]
b. 12 Nov 1854 d. 12 Nov 1854
12
Edward Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.13.6.1.7]
b. 7 Feb 1858 d. 9 May 1930
11
Benjamin B Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.13.6.2]
b. 28 Feb 1808
10
Samuel Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.13.7]
b. 18 Oct 1788 d. 20 Oct 1859
10
Elisha Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.13.8]
b. 15 Feb 1791 d. 26 Dec 1849
10
Elizabeth Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.13.9]
b. 2 Feb 1795
9
Phila Taft
[1.1.1.1.1.1.2.2.14]
b. Abt 1748 d. 1794
8
Mary Taft
[1.1.1.1.1.1.2.3]
b. 21 Dec 1700 d. 1755
Benjamin Albee
b. 1 Nov 1694 d. 24 Jun 1755
9
Deacon Gideon Albee
[1.1.1.1.1.1.2.3.1]
b. 1 Mar 1723 d. 18 Oct 1799
9
Susanna Albee
[1.1.1.1.1.1.2.3.2]
b. Abt 1725 d. 8 Aug 1802
9
Jemima Albee
[1.1.1.1.1.1.2.3.3]
b. 7 Oct 1731 d. 7 Oct 1782
9
Peter Albee
[1.1.1.1.1.1.2.3.4]
b. 19 Jan 1736
9
Stephen Albee
[1.1.1.1.1.1.2.3.5]
b. Abt 1740
8
Elizabeth Taft
[1.1.1.1.1.1.2.4]
b. 18 Jun 1704 d. 1748
Peter Marvel
b. 1700 d. 26 Sep 1735
9
Margaret Marvel
[1.1.1.1.1.1.2.4.1]
b. Abt 1729
9
Tristan Marvel
[1.1.1.1.1.1.2.4.2]
b. Abt 1730 d. 29 Feb 1748
8
Alice Taft
[1.1.1.1.1.1.2.5]
b. 27 Jun 1707
+
Briggs
b. Abt 1700 d. Aft 1727
8
Eunice Taft
[1.1.1.1.1.1.2.6]
b. 20 Feb 1709 d. 27 Feb 1787
Obadiah Walker
b. 9 Oct 1691 d. 9 Jun 1760
9
Benjamin Walker
[1.1.1.1.1.1.2.6.1]
b. 30 Sep 1746 d. Bef 23 Nov 1813
8
John Taft
[1.1.1.1.1.1.2.7]
b. 18 Dec 1710 d. 19 Apr 1769
Hannah Cheney
b. 13 Feb 1711 d. 22 Feb 1759
9
Eunice Taft
[1.1.1.1.1.1.2.7.1]
b. 18 Jun 1735
Colonel Joseph Reed
b. 6 Mar 1731
10
Nathan Reed
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.1]
b. 9 Dec 1754
10
Eunice Reed
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.2]
b. 26 Dec 1755
10
Major Cheney Reed
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.3]
b. Abt 1759 d. 18 May 1822
10
Joseph Reed
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.4]
b. 1 Sep 1760
10
Hannah Reed
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.5]
b. 24 Jul 1762
9
Hannah Taft
[1.1.1.1.1.1.2.7.2]
b. 4 Jul 1737 d. 2 Feb 1740
9
John Taft
[1.1.1.1.1.1.2.7.3]
b. 2 Jan 1740 d. 1 Feb 1808
Mary Harwood
b. 10 Jun 1745 d. 2 Jun 1782
10
Susanna Taft
[1.1.1.1.1.1.2.7.3.1]
b. 6 Mar 1763 d. 12 Feb 1846
10
Olive Taft
[1.1.1.1.1.1.2.7.3.2]
b. 11 Apr 1765
10
Margary Taft
[1.1.1.1.1.1.2.7.3.3]
b. 21 Aug 1767
10
Hulda Taft
[1.1.1.1.1.1.2.7.3.4]
b. 7 Apr 1770
9
Hannah Taft
[1.1.1.1.1.1.2.7.4]
b. 5 Jun 1744
9
Bethiah Taft
[1.1.1.1.1.1.2.7.5]
b. 9 Aug 1747
9
Robert Taft
[1.1.1.1.1.1.2.7.6]
b. 21 Jul 1749
Chloe Taft
b. 7 Jun 1753 d. 17 Oct 1843
10
Hannah Taft
[1.1.1.1.1.1.2.7.6.1]
b. 21 Mar 1772 d. 3 Aug 1802
10
Josiah Taft
[1.1.1.1.1.1.2.7.6.2]
b. 6 Jul 1776 d. 1845
10
Abigail Taft
[1.1.1.1.1.1.2.7.6.3]
b. 17 Aug 1778 d. 31 Oct 1850
10
Jesse Taft
[1.1.1.1.1.1.2.7.6.4]
b. 3 Feb 1781 d. 10 Jun 1783
10
Jesse Taft
[1.1.1.1.1.1.2.7.6.5]
b. 30 Apr 1782 d. 15 Oct 1869
10
Chloe Taft
[1.1.1.1.1.1.2.7.6.6]
b. 20 Jan 1786 d. 1809
10
Robert Taft
[1.1.1.1.1.1.2.7.6.7]
b. 26 Nov 1788 d. 16 Apr 1865
9
Josiah Taft
[1.1.1.1.1.1.2.7.7]
b. 29 Nov 1752
9
Mary Taft
[1.1.1.1.1.1.2.7.8]
b. 14 Feb 1753 d. 19 Jul 1832
Jacob Taft
b. 1 Dec 1751 d. 30 May 1823
10
Lois Taft
[1.1.1.1.1.1.2.7.8.1]
b. 27 Aug 1780 d. 27 Apr 1854
Josiah Seagrave
b. 14 Oct 1773 d. 20 Mar 1855
11
Mary Ann Seagrave
[1.1.1.1.1.1.2.7.8.1.1]
b. 17 Nov 1799 d. 10 Feb 1825
11
Jacob Taft Seagraves
[1.1.1.1.1.1.2.7.8.1.2]
b. 8 Apr 1802 d. 24 Sep 1870
11
Henrietta Frost Seagrave
[1.1.1.1.1.1.2.7.8.1.3]
b. 1 Dec 1803 d. 1 Jun 1823
11
Waity Grant Seagrave
[1.1.1.1.1.1.2.7.8.1.4]
b. 23 Sep 1805 d. 27 Jan 1859
11
Edward Seagrave
[1.1.1.1.1.1.2.7.8.1.5]
b. 3 Sep 1807 d. 15 Feb 1873
11
Lois Taft Seagrave
[1.1.1.1.1.1.2.7.8.1.6]
b. 13 Apr 1809 d. 19 Mar 1853
11
Josiah Seagrave, Jr
[1.1.1.1.1.1.2.7.8.1.7]
b. 24 May 1811 d. 21 Jul 1861
11
Malvina Seagrave
[1.1.1.1.1.1.2.7.8.1.8]
b. 2 Apr 1813 d. 16 Dec 1823
11
Caleb Seagrave
[1.1.1.1.1.1.2.7.8.1.9]
b. 8 Feb 1815 d. 14 Nov 1823
11
Son Seagrave
[1.1.1.1.1.1.2.7.8.1.10]
b. 3 May 1817 d. 3 May 1817
11
Daughter Seagrave
[1.1.1.1.1.1.2.7.8.1.11]
b. 3 May 1817 d. 3 May 1817
11
Esborn Seagrave
[1.1.1.1.1.1.2.7.8.1.12]
b. 28 Dec 1818 d. 27 Oct 1856
11
George Augustus Seagrave
[1.1.1.1.1.1.2.7.8.1.13]
b. 6 Jan 1823 d. 15 Nov 1884
10
Hannah Margaret Taft
[1.1.1.1.1.1.2.7.8.2]
b. 28 Nov 1782 d. 2 Apr 1857
Stephen Carpenter
b. 13 Aug 1778 d. 1 Oct 1854
11
Eunice Carpenter
[1.1.1.1.1.1.2.7.8.2.1]
b. Sep 1802 d. Mar 1864
11
Orsmus T Carpenter
[1.1.1.1.1.1.2.7.8.2.2]
b. Jan 1805 d. 4 Apr 1863
11
Joseph Rawson Carpenter
[1.1.1.1.1.1.2.7.8.2.3]
b. 2 Apr 1807 d. May 1839
11
Charlotte Taft Carpenter
[1.1.1.1.1.1.2.7.8.2.4]
b. 4 Feb 1809 d. 5 Sep 1845
11
Charles A Carpenter
[1.1.1.1.1.1.2.7.8.2.5]
b. 11 Feb 1813 d. 12 Aug 1887
11
Mary T Carpenter
[1.1.1.1.1.1.2.7.8.2.6]
b. 1815
11
Hannah Taft Carpenter
[1.1.1.1.1.1.2.7.8.2.7]
b. 20 Aug 1817 d. 17 Dec 1890
11
Nancy Carter Carpenter
[1.1.1.1.1.1.2.7.8.2.8]
b. 5 Jun 1820 d. 15 May 1898
11
Henrietta Carpenter
[1.1.1.1.1.1.2.7.8.2.9]
b. Apr 1823 d. Feb 1847
11
George Carpenter
[1.1.1.1.1.1.2.7.8.2.10]
b. 13 Jan 1825
10
Elisabeth Taft
[1.1.1.1.1.1.2.7.8.3]
b. 8 Nov 1784
Ephraim Taft
b. 18 Aug 1780
11
Mary Ann Taft
[1.1.1.1.1.1.2.7.8.3.1]
b. 22 May 1805
11
Ephriam Taft
[1.1.1.1.1.1.2.7.8.3.2]
b. 8 Feb 1807
10
Mary Taft
[1.1.1.1.1.1.2.7.8.4]
b. 16 Mar 1786 d. 25 Feb 1860
10
Charlotte Taft
[1.1.1.1.1.1.2.7.8.5]
b. 25 Feb 1789
10
John Taft
[1.1.1.1.1.1.2.7.8.6]
b. 3 Dec 1792 d. 29 May 1826
Lucretia Newell
b. 24 Sep 1795 d. 29 Dec 1863
11
Robert Taft
[1.1.1.1.1.1.2.7.8.6.1]
b. 27 May 1819
11
Jacob Taft
[1.1.1.1.1.1.2.7.8.6.2]
b. 19 May 1823
10
Orsmus Taft
[1.1.1.1.1.1.2.7.8.7]
b. 1 Jan 1795
Deborah White
b. 16 Feb 1722 d. 26 Oct 1806
9
Nathan Taft
[1.1.1.1.1.1.2.7.9]
b. 20 Oct 1766
9
Samuel Taft
[1.1.1.1.1.1.2.7.10]
b. 6 Feb 1769
8
Jemima Taft
[1.1.1.1.1.1.2.8]
b. 1 Apr 1713 d. 14 Oct 1787
Peter White
b. 6 Dec 1714 d. 8 May 1782
9
Joseph White
[1.1.1.1.1.1.2.8.1]
b. 25 Jun 1738 d. 1805
9
Bethaih White
[1.1.1.1.1.1.2.8.2]
b. 1 Mar 1740 d. 1809
9
Elisabeth White
[1.1.1.1.1.1.2.8.3]
b. 13 Dec 1743
9
Peter White
[1.1.1.1.1.1.2.8.4]
b. 1746 d. 2 Dec 1821
9
Jemima White
[1.1.1.1.1.1.2.8.5]
b. Abt 1754 d. Abt 1782
9
Nathan White
[1.1.1.1.1.1.2.8.6]
b. 10 Jan 1755 d. 21 Jan 1828
8
Gideon Taft
[1.1.1.1.1.1.2.9]
b. 4 Oct 1715 d. 1761
Elizabeth
b. Abt 1715
9
Nathan Taft
[1.1.1.1.1.1.2.9.1]
b. Abt 1735 d. 1 Dec 1741
9
Jemima Taft
[1.1.1.1.1.1.2.9.2]
b. 8 Sep 1736 d. 1 Aug 1742
9
Gideon Taft
[1.1.1.1.1.1.2.9.3]
b. 10 Nov 1738
9
Timothy Taft
[1.1.1.1.1.1.2.9.4]
b. 10 Sep 1740 d. 23 Nov 1741
9
Asa Taft
[1.1.1.1.1.1.2.9.5]
b. 8 May 1747 d. 10 Dec 1802
9
Elizabeth Taft
[1.1.1.1.1.1.2.9.6]
b. 1 Mar 1750
9
Phineas Taft
[1.1.1.1.1.1.2.9.7]
b. 29 Jan 1754 d. 6 Nov 1828
Jemima Thomson
b. 26 Jan 1752 d. 2 Dec 1837
10
Gideon Taft
[1.1.1.1.1.1.2.9.7.1]
b. 2 Mar 1776 d. 17 Nov 1859
10
David Taft
[1.1.1.1.1.1.2.9.7.2]
b. 1777 d. 1812
10
Mary Susan Taft
[1.1.1.1.1.1.2.9.7.3]
b. 1 Dec 1782 d. 28 Nov 1862
10
Cynthia Taft
[1.1.1.1.1.1.2.9.7.4]
b. Abt 1780 d. 8 Feb 1877
10
Otis Taft
[1.1.1.1.1.1.2.9.7.5]
b. 1785 d. 23 Apr 1855
10
Phineas Taft
[1.1.1.1.1.1.2.9.7.6]
b. 1790
10
Crispin Taft
[1.1.1.1.1.1.2.9.7.7]
b. 10 Feb 1793 d. 30 Jun 1862
9
Louise Taft
[1.1.1.1.1.1.2.9.8]
b. Jul 1756
7
Daniel Taft
[1.1.1.1.1.1.3]
b. 1677 d. 24 Aug 1761
Lydia Chapin
b. 29 Sep 1677 d. 31 Mar 1758
8
Abigail Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1]
b. 14 Sep 1707 d. 1736
Abraham Staples
b. 3 Apr 1706 d. Aug 1767
9
Debarah Staples
[1.1.1.1.1.1.3.1.1]
b. 16 Oct 1727
9
Abigail Staples
[1.1.1.1.1.1.3.1.2]
b. 12 Oct 1729 d. 31 Dec 1813
Benoni Benson
b. 18 Jul 1724 d. 10 Jan 1806
10
Henry Benson
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1]
b. Abt 1778
10
Joseph Benson
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.2]
b. Abt 1784
9
Abraham Staples
[1.1.1.1.1.1.3.1.3]
b. 4 Apr 1731 d. 20 Oct 1803
Marcy Harvey
b. 1 Jun 1731 d. 1772
10
Jonathan Staples
[1.1.1.1.1.1.3.1.3.1]
b. 29 Mar 1754 d. 28 Nov 1832
Rachel Holbrook
b. 6 Nov 1753 d. 9 Mar 1832
11
Sally Staples
[1.1.1.1.1.1.3.1.3.1.1]
b. 3 Oct 1779
11
Sylvia Staples
[1.1.1.1.1.1.3.1.3.1.2]
b. 2 Jan 1781 d. 13 Mar 1852
11
Rachael Staples
[1.1.1.1.1.1.3.1.3.1.3]
b. Abt 1784 d. 12 Dec 1870
11
Ellery Staples
[1.1.1.1.1.1.3.1.3.1.4]
b. 1784 d. 1861
11
Willard Staples
[1.1.1.1.1.1.3.1.3.1.5]
b. 20 Dec 1785 d. 20 Dec 1858
11
Jonathan Staples
[1.1.1.1.1.1.3.1.3.1.6]
b. 1792
10
George Staples
[1.1.1.1.1.1.3.1.3.2]
b. 9 Mar 1756 d. 23 Sep 1820
10
Abagail Staples
[1.1.1.1.1.1.3.1.3.3]
b. 9 Aug 1758 d. 1825
10
Lydia Staples
[1.1.1.1.1.1.3.1.3.4]
b. 5 Feb 1761 d. 12 Dec 1818
10
Abraham Staples
[1.1.1.1.1.1.3.1.3.5]
b. 13 Aug 1766
10
Jacob Staples
[1.1.1.1.1.1.3.1.3.6]
b. 2 Oct 1768
10
Mary Staples
[1.1.1.1.1.1.3.1.3.7]
b. 10 Mar 1772
Ruth Daniels
b. 13 Jul 1738 d. 26 Sep 1798
10
Ruth Staples
[1.1.1.1.1.1.3.1.3.8]
b. 22 Feb 1775 d. 10 Aug 1851
Elias Thayer
b. 3 May 1773 d. 26 Jun 1833
11
Hannah Ellis Thayer
[1.1.1.1.1.1.3.1.3.8.1]
b. 19 Mar 1800 d. 26 Feb 1818
Charles Benson Jenckes
b. 10 Apr 1796 d. Aft 1831
12
Charles T Jenckes
[1.1.1.1.1.1.3.1.3.8.1.1]
b. 20 Feb 1818 d. 28 Feb 1818
11
Ruth Daniels Thayer
[1.1.1.1.1.1.3.1.3.8.2]
b. 16 Jul 1802
11
Mary Blake Thayer
[1.1.1.1.1.1.3.1.3.8.3]
b. 26 Nov 1804 d. 1870
11
Elias Thayer
[1.1.1.1.1.1.3.1.3.8.4]
b. 28 Oct 1806 d. 2 Nov 1808
11
Julia Ann Thayer
[1.1.1.1.1.1.3.1.3.8.5]
b. 13 Dec 1808 d. 6 Aug 1833
11
Lyman Wheelock Thayer
[1.1.1.1.1.1.3.1.3.8.6]
b. 6 May 1798 d. 5 Apr 1848
11
Susan Thayer
[1.1.1.1.1.1.3.1.3.8.7]
b. 1 Feb 1811 d. 7 Apr 1812
11
Elias Nelson Thayer
[1.1.1.1.1.1.3.1.3.8.8]
b. 3 Apr 1814 d. 6 Aug 1835
11
John Milton Thayer
[1.1.1.1.1.1.3.1.3.8.9]
b. 24 Jan 1820 d. 19 Mar 1906
10
Lendol Staples
[1.1.1.1.1.1.3.1.3.9]
b. 1777
10
Susannah Staples
[1.1.1.1.1.1.3.1.3.10]
b. 21 Jul 1780 d. 11 Feb 1818
9
Lydia Staples
[1.1.1.1.1.1.3.1.4]
b. 1746 d. Abt 1843
8
Josiah Taft
[1.1.1.1.1.1.3.2]
b. 2 Apr 1709 d. 30 Sep 1756
Lydia Chapin
b. 2 Feb 1711 d. 9 Nov 1778
9
Josiah Taft
[1.1.1.1.1.1.3.2.1]
b. 10 May 1733 d. 18 Aug 1761
9
Ebenezer Taft
[1.1.1.1.1.1.3.2.2]
b. 20 Aug 1735 d. 16 Oct 1735
9
Caleb Taft
[1.1.1.1.1.1.3.2.3]
b. 1738 d. 19 Sep 1756
9
Asahael Taft
[1.1.1.1.1.1.3.2.4]
b. 23 Apr 1740
9
Joel Taft
[1.1.1.1.1.1.3.2.5]
b. 15 Aug 1742 d. 23 Dec 1745
9
Joel Taft
[1.1.1.1.1.1.3.2.6]
b. 19 Feb 1747 d. 30 Aug 1749
9
Barzillai Taft
[1.1.1.1.1.1.3.2.7]
b. 3 Nov 1750 d. 21 Jan 1839
Abigail Taft
b. 5 Oct 1754 d. 12 Aug 1775
10
Eunice Taft
[1.1.1.1.1.1.3.2.7.1]
b. 28 Jan 1775 d. 30 May 1861
Phineas Chapin
b. 3 Aug 1769 d. 3 May 1839
11
Abby Chapin
[1.1.1.1.1.1.3.2.7.1.1]
b. 1 Feb 1796
11
Laurinda Chapin
[1.1.1.1.1.1.3.2.7.1.2]
b. 6 Feb 1798 d. 20 Dec 1866
11
Sarah Richardson Chapin
[1.1.1.1.1.1.3.2.7.1.3]
b. 30 Apr 1800 d. 16 Apr 1884
11
Chloe T Chapin
[1.1.1.1.1.1.3.2.7.1.4]
b. 8 Apr 1802 d. 5 Oct 1881
11
Mary Warren Chapin
[1.1.1.1.1.1.3.2.7.1.5]
b. 27 Feb 1804 d. 13 Nov 1890
11
Caleb Chapin
[1.1.1.1.1.1.3.2.7.1.6]
b. 6 Feb 1806 d. 27 Sep 1883
Clarissa Wood Taft
b. 3 May 1810 d. 1889
12
Eunice Chapin
[1.1.1.1.1.1.3.2.7.1.6.1]
b. 1 May 1832 d. 29 Sep 1920 [
=>
]
12
Ezra Wood Chapin
[1.1.1.1.1.1.3.2.7.1.6.2]
b. 7 Jun 1836 d. 31 Mar 1909 [
=>
]
12
Edwin Chapin
[1.1.1.1.1.1.3.2.7.1.6.3]
b. 7 Jun 1836 d. 27 Sep 1836
11
Margaret Ann Chapin
[1.1.1.1.1.1.3.2.7.1.7]
b. 16 Jun 1808 d. 15 Nov 1897
11
Bezaileel Taft Chapin
[1.1.1.1.1.1.3.2.7.1.8]
b. 21 Oct 1810 d. 28 May 1855
11
Samuel Judson Chapin
[1.1.1.1.1.1.3.2.7.1.9]
b. 27 Aug 1812 d. 18 Nov 1908
11
Son Chapin
[1.1.1.1.1.1.3.2.7.1.10]
b. 15 Oct 1815
11
Gardner Spring Chapin
[1.1.1.1.1.1.3.2.7.1.11]
b. 2 Oct 1817 d. 4 Aug 1892
11
Josiah Spring Chapin
[1.1.1.1.1.1.3.2.7.1.12]
b. 24 Aug 1820 d. 26 Dec 1882
Sarah Richardson
b. 26 Sep 1756 d. 27 Apr 1809
10
Abigail Taft
[1.1.1.1.1.1.3.2.7.2]
b. 5 Dec 1777 d. 24 Sep 1778
10
Bezaleel Taft
[1.1.1.1.1.1.3.2.7.3]
b. 8 Sep 1780 d. 16 Jul 1846
10
Sally Taft
[1.1.1.1.1.1.3.2.7.4]
b. 2 Nov 1783 d. 12 Nov 1808
10
Caleb Taft
[1.1.1.1.1.1.3.2.7.5]
b. 20 Dec 1786 d. 3 Nov 1805
10
Chloe Taft
[1.1.1.1.1.1.3.2.7.6]
b. 10 Mar 1793 d. 3 Apr 1869
9
Chloe Taft
[1.1.1.1.1.1.3.2.8]
b. 7 Jun 1753 d. 17 Oct 1843
Robert Taft
b. 21 Jul 1749
10
Hannah Taft
[1.1.1.1.1.1.3.2.8.1]
b. 21 Mar 1772 d. 3 Aug 1802
10
Josiah Taft
[1.1.1.1.1.1.3.2.8.2]
b. 6 Jul 1776 d. 1845
10
Abigail Taft
[1.1.1.1.1.1.3.2.8.3]
b. 17 Aug 1778 d. 31 Oct 1850
10
Jesse Taft
[1.1.1.1.1.1.3.2.8.4]
b. 3 Feb 1781 d. 10 Jun 1783
10
Jesse Taft
[1.1.1.1.1.1.3.2.8.5]
b. 30 Apr 1782 d. 15 Oct 1869
10
Chloe Taft
[1.1.1.1.1.1.3.2.8.6]
b. 20 Jan 1786 d. 1809
10
Robert Taft
[1.1.1.1.1.1.3.2.8.7]
b. 26 Nov 1788 d. 16 Apr 1865
8
David Taft
[1.1.1.1.1.1.3.3]
b. 19 Apr 1711 d. 12 Oct 1756
Johanna Lovett
b. 12 May 1714 d. 25 Apr 1776
9
David Taft
[1.1.1.1.1.1.3.3.1]
b. 1736 d. 3 Sep 1769
9
Abigail Taft
[1.1.1.1.1.1.3.3.2]
b. 21 Jun 1739 d. Bef 1769
9
Phineas Taft
[1.1.1.1.1.1.3.3.3]
b. Abt 1741 d. 16 Jan 1745
9
Ephraim Taft
[1.1.1.1.1.1.3.3.4]
b. 14 Jul 1749
9
Joanna Taft
[1.1.1.1.1.1.3.3.5]
b. 14 Nov 1751 d. 3 Oct 1777
John Benson
b. 1 Aug 1749 d. 18 May 1818
10
Lovett Benson
[1.1.1.1.1.1.3.3.5.1]
b. 6 Oct 1772 d. 4 Mar 1773
10
Lois Benson
[1.1.1.1.1.1.3.3.5.2]
b. 17 Jul 1774 d. 10 Jul 1840
Manassah Baker
b. 4 Oct 1765 d. 30 Jun 1831
11
Sarah Williams Baker
[1.1.1.1.1.1.3.3.5.2.1]
b. 8 Feb 1796
Andre Taft
b. 25 Jun 1792 d. 26 Jun 1850
12
Margary Ann Taft
[1.1.1.1.1.1.3.3.5.2.1.1]
b. 4 May 1818 d. 4 Nov 1904 [
=>
]
12
Caroline Taft
[1.1.1.1.1.1.3.3.5.2.1.2]
b. 21 Aug 1821 d. 7 Nov 1907 [
=>
]
11
Sawyer Baker
[1.1.1.1.1.1.3.3.5.2.2]
b. 5 Nov 1797 d. 14 Oct 1802
11
Mary Sawyer Baker
[1.1.1.1.1.1.3.3.5.2.3]
b. 1 Apr 1800
11
Bezaleel Sawyer Baker
[1.1.1.1.1.1.3.3.5.2.4]
b. 13 Sep 1802
11
William Henry Baker
[1.1.1.1.1.1.3.3.5.2.5]
b. 8 Jun 1805
11
Chloe Taft Baker
[1.1.1.1.1.1.3.3.5.2.6]
b. 17 Dec 1807
Faton Walker
12
Henry E Walker
[1.1.1.1.1.1.3.3.5.2.6.1]
b. 15 Mar 1836
12
Harriet E Walker
[1.1.1.1.1.1.3.3.5.2.6.2]
b. 15 Mar 1836 d. 30 Nov 1837
12
Edmund Walker
[1.1.1.1.1.1.3.3.5.2.6.3]
b. 18 Dec 1837 d. 10 May 1844
12
Edgar Walker
[1.1.1.1.1.1.3.3.5.2.6.4]
b. 18 Dec 1837 d. 24 Jan 1844
12
Adeline N Walker
[1.1.1.1.1.1.3.3.5.2.6.5]
b. 7 Feb 1845 d. 1848
11
John William Baker
[1.1.1.1.1.1.3.3.5.2.7]
b. 29 Sep 1810
11
Hannah Dike Baker
[1.1.1.1.1.1.3.3.5.2.8]
b. 8 Nov 1813 d. 3 Jul 1836
11
John Brooks Baker
[1.1.1.1.1.1.3.3.5.2.9]
b. 30 Jul 1816
11
Caleb Strong Baker
[1.1.1.1.1.1.3.3.5.2.10]
b. 30 Jul 1816 d. 29 Dec 1834
10
Prudence Benson
[1.1.1.1.1.1.3.3.5.3]
b. 4 May 1776 d. 16 May 1789
9
James Taft
[1.1.1.1.1.1.3.3.6]
b. 25 Oct 1754 d. 14 Oct 1756
8
Lydia Taft
[1.1.1.1.1.1.3.4]
b. 13 Apr 1713 d. 17 Aug 1793
Charles Sheldon
b. Abt 1709 d. 20 Jul 1763
9
Timothy Sheldon
[1.1.1.1.1.1.3.4.1]
b. 17 Feb 1739 d. 1757
9
Lydia Sheldon
[1.1.1.1.1.1.3.4.2]
b. 1742 d. 1757
9
Daniel Sheldon
[1.1.1.1.1.1.3.4.3]
b. 8 Jan 1743 d. Feb 1821
9
Charles Sheldon
[1.1.1.1.1.1.3.4.4]
b. 26 Aug 1746 d. 14 Mar 1832
9
Hannah Sheldon
[1.1.1.1.1.1.3.4.5]
b. 10 Jul 1751 d. 11 Jun 1783
9
Ephraim Sheldon
[1.1.1.1.1.1.3.4.6]
b. 21 May 1754 d. 22 Apr 1840
8
Daniel Taft
[1.1.1.1.1.1.3.5]
b. 15 Apr 1715 d. 1761
Hopestill White
b. 15 Jul 1717
9
Mary Taft
[1.1.1.1.1.1.3.5.1]
b. Abt 1737 d. 24 Dec 1817
9
Comfort Taft
[1.1.1.1.1.1.3.5.2]
b. Abt 1739 d. 16 Mar 1824
9
Beulah Taft
[1.1.1.1.1.1.3.5.3]
b. 10 Feb 1740 d. Dec 1828
9
Hephzibah Taft
[1.1.1.1.1.1.3.5.4]
b. 10 Feb 1740 d. Bef 1749
9
Amos Taft
[1.1.1.1.1.1.3.5.5]
b. 25 Apr 1745 d. Sep 1767
9
Deborah Taft
[1.1.1.1.1.1.3.5.6]
b. 6 Apr 1747
9
Hopestill Taft
[1.1.1.1.1.1.3.5.7]
b. 4 Jan 1749 d. Jun 1840
9
Daniel Taft
[1.1.1.1.1.1.3.5.8]
b. 22 Jul 1751 d. 12 May 1810
9
Jehoshaba Taft
[1.1.1.1.1.1.3.5.9]
b. 1755
9
Alpheus Taft
[1.1.1.1.1.1.3.5.10]
b. 11 Jan 1757
9
Zadoch Taft
[1.1.1.1.1.1.3.5.11]
b. 4 Feb 1759
9
Patience Taft
[1.1.1.1.1.1.3.5.12]
b. 16 Nov 1762 d. 12 May 1810
8
Japhet Taft
[1.1.1.1.1.1.3.6]
b. 24 Mar 1721 d. 24 Aug 1761
8
Caleb Taft
[1.1.1.1.1.1.3.7]
b. 1724 d. 1762
8
Ephraim Taft
[1.1.1.1.1.1.3.8]
b. 25 May 1718 d. 6 May 1748
Anna Read
b. 25 Oct 1728 d. 12 Mar 1797
9
Anna Taft
[1.1.1.1.1.1.3.8.1]
b. 14 Apr 1748 d. 3 Apr 1830
Stephen Taft
b. 21 Aug 1734 d. 3 Feb 1803
10
Lydia Taft
[1.1.1.1.1.1.3.8.1.1]
b. 13 Oct 1766 d. 13 Jan 1847
10
Hazeltine Taft
[1.1.1.1.1.1.3.8.1.2]
b. 6 Jan 1769 d. 18 Jul 1856
10
Gravenor Taft
[1.1.1.1.1.1.3.8.1.3]
b. 1773 d. 1838
10
Marcy Taft
[1.1.1.1.1.1.3.8.1.4]
b. 5 Sep 1775
10
Ephraim Taft
[1.1.1.1.1.1.3.8.1.5]
b. 18 Aug 1780
Elisabeth Taft
b. 8 Nov 1784
11
Mary Ann Taft
[1.1.1.1.1.1.3.8.1.5.1]
b. 22 May 1805
11
Ephriam Taft
[1.1.1.1.1.1.3.8.1.5.2]
b. 8 Feb 1807
10
Lovice Taft
[1.1.1.1.1.1.3.8.1.6]
b. 1 Jul 1783
10
Anna Taft
[1.1.1.1.1.1.3.8.1.7]
b. 29 Nov 1784
10
Stephen Taft
[1.1.1.1.1.1.3.8.1.8]
b. 12 Dec 1787
10
Adolphas Taft
[1.1.1.1.1.1.3.8.1.9]
b. 2 Oct 1791
7
Captain Joseph Taft
[1.1.1.1.1.1.4]
b. 1680 d. 18 Jun 1747
Elizabeth Emerson
b. 6 Mar 1686 d. 18 Jun 1747
8
Lucy Taft
[1.1.1.1.1.1.4.1]
b. 22 Sep 1709
8
Lieutenant Moses Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2]
b. 30 Jan 1712 d. 16 Jul 1778
Priscilla Thayer
b. 6 Jun 1717 d. Aft 1761
9
Lieutenant Abner Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.1]
b. 28 Dec 1736 d. 30 May 1809
Tryal White
b. 8 May 1737 d. 14 Jun 1814
10
Oliver Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.1.1]
b. 1 May 1758 d. 16 Jul 1775
10
Moses Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.1.2]
b. 29 Sep 1760 d. 4 Dec 1848
Judith Cummings
b. 26 Nov 1766 d. 26 Nov 1816
11
Nancy Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.1.2.1]
b. 10 Mar 1787
11
Samuel Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.1.2.2]
b. 24 Sep 1790 d. 11 Oct 1863
11
Lucy Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.1.2.3]
b. 24 Apr 1795 d. 21 Jun 1847
11
Newell Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.1.2.4]
b. 28 Jul 1804 d. 4 Nov 1873
Hannah G Taft
b. 18 May 1802 d. 8 Jan 1843
12
Albert Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.1.2.4.1]
b. 28 Aug 1823 d. Aft 1874 [
=>
]
12
Marcy Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.1.2.4.2]
b. Mar 1829 d. 12 Apr 1830
12
Charles M Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.1.2.4.3]
b. Jan 1843 d. 7 Dec 1843
11
Sylvia Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.1.2.5]
b. 23 Aug 1810 d. 3 Aug 1816
10
Mary Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.1.3]
b. 12 Oct 1767 d. 18 Aug 1775
10
Webb Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.1.4]
b. 26 Mar 1772 d. 21 Apr 1842
Lucy Taft
b. 9 Jun 1774 d. 14 Mar 1846
11
Lucinda Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.1.4.1]
b. 22 Nov 1793
11
Jason Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.1.4.2]
b. 5 Jun 1796 d. 25 Oct 1861
10
Trial T Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.1.5]
b. 13 Apr 1777 d. 18 Aug 1815
9
James Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.2]
b. 9 Apr 1738 d. 14 Jan 1826
Esther Taft
b. 9 Jan 1747 d. 3 Feb 1834
10
Lucy Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.1]
b. 22 Nov 1769 d. 29 Jul 1845
Ebenezer Winslow
b. 21 Jan 1772 d. 21 Feb 1841
11
Albert Winslow
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.1.1]
b. 24 Jul 1797
Sarah Gardner
b. 25 Jul 1803 d. 23 Sep 1840
12
Martha Maria Winslow
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.1.1.1]
b. 12 Mar 1826 d. 16 Mar 1842
12
Preston Willard Winslow
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.1.1.2]
b. 13 Nov 1828 [
=>
]
12
Mary Augusta Allen Winslow
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.1.1.3]
b. 14 Sep 1831
12
John Alvin Winslow
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.1.1.4]
b. 3 Jul 1834
12
Jasper Ross Winslow
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.1.1.5]
b. 7 Apr 1837 d. 25 Oct 1841
12
Sarah Adaline Winslow
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.1.1.6]
b. 20 Dec 1839 d. 9 Dec 1841
Sylvia Babbit
b. 27 Jan 1814
12
Jasper Albert Winslow
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.1.1.7]
b. 15 Apr 1842 d. 14 Oct 1864
11
Claramond Winslow
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.1.2]
b. 10 Feb 1799 d. 27 Apr 1834
John Hathaway
b. 22 May 1797
12
Son Hathaway
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.1.2.1]
b. Apr 1828 d. 14 Apr 1828
12
Francis Ebenezer Hathaway
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.1.2.2]
b. 9 Mar 1829 [
=>
]
12
Catherine Elizabeth Hathaway
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.1.2.3]
b. 18 Feb 1833
12
George H Hathaway
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.1.2.4]
b. 13 Aug 1839 [
=>
]
11
Alvin Winslow
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.1.3]
b. 27 Aug 1802 d. 9 Oct 1803
11
Paulina Maria Winslow
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.1.4]
b. 27 May 1805
+
Austin Crosby
b. 10 Mar 1805 d. 13 Jun 1868
11
Lucy Emma Winslow
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.1.5]
b. 17 Feb 1808 d. 20 Feb 1870
+
Matthew Henry McClary
b. 10 Mar 1801
10
Zilpha Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.2]
b. 1 Jul 1772 d. 24 Feb 1848
Nathan Fisher
b. 25 Jun 1770 d. 21 Mar 1847
11
Elias Fisher
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.2.1]
b. 10 Jul 1796
11
Elise Fisher
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.2.2]
b. 10 Jul 1796
11
Josiah Fisher
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.2.3]
b. 26 Feb 1798 d. 11 Apr 1799
11
Josiah Fisher
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.2.4]
b. 1 Dec 1801
11
Rachel Adaline Fisher
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.2.5]
b. 29 Jan 1804
+
Moses Daniels Southwick
11
Mary Caroline Fisher
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.2.6]
b. 22 Mar 1806
11
Nathan Fisher
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.2.7]
b. 21 Mar 1811
10
Irena Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.3]
b. 25 Oct 1774 d. 29 May 1790
10
Ezekial Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.4]
b. 21 Jan 1777 d. 24 Apr 1841
+
Olive Thayer
b. 10 Aug 1782 d. 1865
10
James Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.5]
b. 13 Jun 1780
10
Luke Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.6]
b. 3 Jun 1783
Nancy Wood
b. 6 Feb 1787 d. 6 May 1859
11
Clarissa Wood Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.6.1]
b. 3 May 1810 d. 1889
Caleb Chapin
b. 6 Feb 1806 d. 27 Sep 1883
12
Eunice Chapin
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.6.1.1]
b. 1 May 1832 d. 29 Sep 1920 [
=>
]
12
Ezra Wood Chapin
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.6.1.2]
b. 7 Jun 1836 d. 31 Mar 1909 [
=>
]
12
Edwin Chapin
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.6.1.3]
b. 7 Jun 1836 d. 27 Sep 1836
11
Moses Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.6.2]
b. 26 Jan 1812
Sylvia Ann Wheelock
b. 3 Feb 1815 d. 3 Oct 1855
12
Sarah Wood Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.6.2.1]
b. 6 Jan 1838 [
=>
]
12
Susan Hortense Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.6.2.2]
b. 5 Jan 1843
12
Luke Herbert Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.6.2.3]
b. 9 Nov 1846
11
Sarah Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.6.3]
b. 15 Jan 1815 d. 24 Dec 1898
Amariah Albee Wood
b. 2 Nov 1802 d. 14 Jun 1871
12
Sarah A Wood
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.6.3.1]
b. May 1837 d. 26 Sep 1837
12
Samuel Taft Wood
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.6.3.2]
b. 4 Oct 1841 d. Jun 1925 [
=>
]
12
Mary Baylies Wood
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.6.3.3]
b. 29 Apr 1847 d. 9 Sep 1847
12
Anna I Wood
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.6.3.4]
b. 18 Aug 1848 d. 1919
11
Irene Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.6.4]
b. 19 Sep 1816 d. 26 Jan 1900
Silas Mandeville Wheelock
b. 11 Nov 1817 d. 18 Oct 1901
12
Ellen Maria Wheelock
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.6.4.1]
b. 2 Sep 1842 d. 1871
12
Eugene Augustus Wheelock
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.6.4.2]
b. 15 Feb 1846 d. 14 Sep 1912 [
=>
]
12
Alice Augusta Wheelock
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.6.4.3]
b. 22 Jan 1849 d. Sep 1891
12
Arthur Wheelock
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.6.4.4]
b. 26 Mar 1851 d. 23 Sep 1927 [
=>
]
12
Henry Wheelock
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.6.4.5]
b. 14 Jan 1857 d. 13 Nov 1881
11
Chloe M Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.6.5]
b. 5 Feb 1823
Luke Southwick Farnham
b. 20 Jan 1817 d. 23 Aug 1883
12
Elizabeth Southwick Farnham
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.6.5.1]
b. 1852
12
Ella Frances Farnham
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.6.5.2]
b. 1855
12
Moses Taft Farnham
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.6.5.3]
b. 1858
12
Walter James Farnham
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.6.5.4]
b. 1862
11
James Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.6.6]
b. 1830
10
Esther Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.7]
b. 5 Aug 1786 d. 10 Aug 1858
Fuller Murdock
b. 17 Feb 1781 d. 8 Nov 1857
11
Philena Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.7.1]
b. 26 Aug 1807 d. 30 Jun 1835
Samuel Merriam
b. Abt 1803
12
George Nison Merriam
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.7.1.1]
b. 26 Dec 1834 d. 19 Nov 1903 [
=>
]
11
Abba Eliza Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.7.2]
b. 13 Nov 1808 d. 4 Apr 1834
Pemberton Brown
b. 11 Oct 1801 d. 30 Mar 1870
12
Tarissa Gregory Brown
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.7.2.1]
b. 3 Oct 1828 d. 12 Oct 1914 [
=>
]
12
Josephine Brown
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.7.2.2]
b. 29 Jan 1830 d. 16 Jan 1895 [
=>
]
12
Adin Ballou Brown
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.7.2.3]
b. 14 Nov 1831 d. 19 Apr 1880
12
Edin Ballow Brown
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.7.2.4]
b. 14 Nov 1831
12
Abba Eliza Brown
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.7.2.5]
b. 30 Jun 1833 d. 19 Oct 1914 [
=>
]
11
Moses Taft Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.7.3]
b. 12 Sep 1810 d. 7 Feb 1883
Dorinda Wood Grout
b. 19 Aug 1810 d. 15 Jan 1888
12
Cyrus Grout Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.7.3.1]
b. 16 Jun 1833 d. 7 Jun 1913 [
=>
]
12
Lewis Henry Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.7.3.2]
b. 17 Mar 1835 d. 25 Mar 1916 [
=>
]
12
Sarah A Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.7.3.3]
b. Jul 1837 d. 1 Sep 1838
12
Lucius Walter Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.7.3.4]
b. 11 Apr 1846 d. 1 Jul 1867
12
Samuel Justin Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.7.3.5]
b. 13 May 1848 d. 11 May 1910 [
=>
]
12
Lyman Wood Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.7.3.6]
b. 26 Dec 1853 d. Bef 1900 [
=>
]
11
John Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.7.4]
b. 9 Sep 1812 d. 13 Sep 1837
11
Charles Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.7.5]
b. 11 Feb 1815 d. 6 Aug 1869
Mary Ann Weightman
b. 3 Apr 1823 d. 11 May 1895
12
Charles W Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.7.5.1]
b. 4 Mar 1854 d. 5 Mar 1916 [
=>
]
11
Caleb Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.7.6]
b. 16 Feb 1817 d. 10 May 1892
Maria Howard Emerson
b. 27 Dec 1830 d. 11 Oct 1901
12
Frank Fuller Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.7.6.1]
b. 18 May 1857 d. 13 Jan 1939 [
=>
]
12
Herbert Emerson Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.7.6.2]
b. 16 Jan 1859 d. 18 Jan 1931 [
=>
]
12
Eugene Clifford Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.7.6.3]
b. 24 Nov 1863 d. 13 Sep 1924
12
Carrie Maria Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.7.6.4]
b. 4 Sep 1865 [
=>
]
11
George Taft Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.7.7]
b. 18 Mar 1819
Abbie Ann Robinson
b. Abt 1825
12
George Thurston Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.7.7.1]
b. 4 Jul 1846 d. 30 Jan 1933 [
=>
]
12
Lizzie Green Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.7.7.2]
b. 2 Sep 1857 d. 3 May 1879 [
=>
]
11
Harriet E. Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.7.8]
b. 6 Feb 1821 d. 30 Nov 1904
David Franum Wood
b. 16 Feb 1818 d. 4 Feb 1896
12
Arthur Eugene Wood
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.7.8.1]
b. 20 Jan 1844 d. 20 Apr 1920 [
=>
]
12
Hattie Esther Wood
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.7.8.2]
b. 5 Aug 1855 [
=>
]
11
Chapin Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.7.9]
b. 20 Jun 1823 d. 17 Sep 1882
Julia A Smith
b. 1824 d. 21 Jun 1909
12
Luther Oscar Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.7.9.1]
b. 6 Oct 1848 d. 1 Nov 1904 [
=>
]
12
Loren Nelson Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.7.9.2]
b. 3 Jul 1850 d. 11 May 1923 [
=>
]
12
Eldoras Filasker Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.7.9.3]
b. 18 Jun 1852 [
=>
]
12
William Fuller Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.7.9.4]
b. 19 Jun 1855 d. 26 Nov 1924 [
=>
]
12
Emma E Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.7.9.5]
b. 30 May 1857 d. 23 Jul 1913 [
=>
]
11
Mary Ann Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.7.10]
b. 18 Jun 1825 d. 27 Aug 1834
10
Moses Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.8]
b. 14 Jul 1788 d. 26 Jun 1810
10
Abigail Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.9]
b. 24 Jan 1791 d. 15 May 1837
Chandler Taft
b. 29 May 1792
11
Augustine Calvin Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.9.1]
b. 11 May 1817
Deborah Millett Taylor
12
Alice Bradford Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.9.1.1]
b. 26 Oct 1841
12
Edward A Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.9.1.2]
b. 8 Apr 1845
9
Ruth Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.3]
b. 19 Feb 1740 d. 27 Jun 1797
9
Moses Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.4]
b. 21 Dec 1742
9
Margaret Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.5]
b. 19 Feb 1743 d. 3 Oct 1761
9
Nahum Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.6]
b. 17 Aug 1745
9
Priscilla Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.7]
b. 30 Apr 1749 d. 12 Sep 1833
Timothy Taft
b. 3 Apr 1750 d. 30 Nov 1808
10
Marcy Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.7.1]
b. 28 Sep 1771 d. 1 Aug 1848
+
Ezekiah Preston
b. Abt 1771
10
Josiah Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.7.2]
b. 3 May 1774
10
Abigail Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.7.3]
b. 14 Jan 1777 d. 17 Dec 1832
Moses Stone
b. 2 Mar 1775 d. 10 May 1803
11
Jonas Stone
[1.1.1.1.1.1.4.2.7.3.1]
b. 6 Jun 1795 d. 30 Sep 1795
11
Sukey Stone
[1.1.1.1.1.1.4.2.7.3.2]
b. 19 Feb 1798
10
Polly Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.7.4]
b. 1779 d. 5 Sep 1785
10
Timothy Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.7.5]
b. 1782 d. 5 Jan 1818
Mary "Polly" Reidel
b. 8 Feb 1784 d. 8 Feb 1863
11
Timothy Clark Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.7.5.1]
b. 21 Jul 1800 d. 11 May 1872
Mary A Hitchcock
b. 4 Jan 1802 d. 26 Oct 1842
12
Samuel Adams Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.7.5.1.1]
b. 11 Mar 1830 d. 5 Feb 1916 [
=>
]
12
Elizabeth C Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.7.5.1.2]
b. 6 Jun 1834 d. 13 Dec 1915 [
=>
]
11
Adolphus Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.7.5.2]
b. Abt 1804
11
Harry Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.7.5.3]
b. Abt 1806
11
Ezekiel Preston Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.7.5.4]
b. Abt 1807
11
Washington Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.7.5.5]
b. Abt 1808 d. Abt 1823
11
Charlotte Clark Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.7.5.6]
b. Abt 1810
+
Hyman Sage
b. Abt 1810
11
Christine Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.7.5.7]
b. 1811 d. 8 Jul 1847
+
George Heath
b. Abt 1811
11
Jacob R Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.7.5.8]
b. 29 Oct 1814 d. 1 Jan 1875
+
Caroline Cowles
b. 10 Jun 1817 d. 25 Jun 1875
10
Joseph Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.7.6]
b. 1784
10
Jonas Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.7.7]
b. 1786
10
Polly Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.7.8]
b. 1788 d. 1859
9
Joseph Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.8]
b. 6 Jul 1751 d. 2 Jul 1828
Hannah Keith
b. 17 Jul 1753 d. 2 Apr 1842
10
Oliver Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.8.1]
b. 6 Nov 1771 d. 20 Feb 1853
Chloe
b. 1782 d. 24 Nov 1841
11
Olive Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.8.1.1]
b. 1 Mar 1806 d. 27 Jan 1867
11
Amariah Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.8.1.2]
b. 19 Sep 1807 d. 28 Aug 1873
Mary Richards
b. Abt 1819 d. 22 Apr 1875
12
Ophelia Adams Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.8.1.2.1]
b. 23 Jan 1841 [
=>
]
12
Mary Elizabeth Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.8.1.2.2]
b. 23 May 1843 d. 8 Apr 1845
12
Francis Amariel Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.8.1.2.3]
b. 18 Sep 1847 d. 28 Jul 1848
11
Oliver Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.8.1.3]
b. 16 Jun 1812 d. 25 Mar 1876
Sarah Richardson
b. 1821
12
Horace H Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.8.1.3.1]
b. 1846 d. 11 May 1863
12
Jennis Isadora Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.8.1.3.2]
b. 12 Apr 1857 d. 21 Aug 1863
11
Maryan Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.8.1.4]
b. 9 Jul 1814
Hosea Aldrich
b. 14 Mar 1803
12
Chloe M Aldrich
[1.1.1.1.1.1.4.2.8.1.4.1]
b. 17 Jan 1838
12
Watee E Aldrich
[1.1.1.1.1.1.4.2.8.1.4.2]
b. 1 Sep 1840
12
Sylvia Ann Aldrich
[1.1.1.1.1.1.4.2.8.1.4.3]
b. 20 Jul 1844
11
George Washington Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.8.1.5]
b. 13 May 1823
Laura Ann M Taft
b. 26 Jun 1824 d. 26 May 1855
11
Laura Ann Maria Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.8.1.6]
b. 7 Jul 1844
11
Son Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.8.1.7]
b. 7 Jul 1844 d. 21 Jul 1844
11
Joseph K Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.8.1.8]
b. 25 Sep 1846 d. Jul 1868
11
Chloe Jane Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.8.1.9]
b. 25 Nov 1849
10
Huldah Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.8.2]
b. 17 Feb 1775 d. Bef 21 May 1780
10
Huldah Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.8.3]
b. 21 May 1780 d. 11 Oct 1811
Parker Tyler
b. 14 Nov 1790 d. 28 Jun 1853
11
Huldah Tyler
[1.1.1.1.1.1.4.2.8.3.1]
b. 4 Oct 1811
Matthew Borland
b. Abt 1800
12
Huldah J Borland
[1.1.1.1.1.1.4.2.8.3.1.1]
b. 28 Sep 1831 d. 10 Nov 1907 [
=>
]
12
Margaret Borland
[1.1.1.1.1.1.4.2.8.3.1.2]
b. 13 Apr 1836 d. 21 Oct 1882 [
=>
]
12
Samuel Borland
[1.1.1.1.1.1.4.2.8.3.1.3]
b. Abt 1841
12
John P Borland
[1.1.1.1.1.1.4.2.8.3.1.4]
b. Abt 1849
11
Hannah Tyler
[1.1.1.1.1.1.4.2.8.3.2]
b. 4 Oct 1811 d. 18 Oct 1811
11
Martha Almira Tyler
[1.1.1.1.1.1.4.2.8.3.3]
b. 28 Sep 1830 d. 16 Oct 1909
William S Jones
b. 26 Sep 1827 d. 26 Sep 1907
12
Anna Almira Jones
[1.1.1.1.1.1.4.2.8.3.3.1]
b. 16 Jun 1850 d. 2 May 1922 [
=>
]
12
Wilber Jones
[1.1.1.1.1.1.4.2.8.3.3.2]
b. 1852
12
Albert J Jones
[1.1.1.1.1.1.4.2.8.3.3.3]
b. 10 Jun 1857 d. 17 Jun 1937 [
=>
]
12
Eva Jones
[1.1.1.1.1.1.4.2.8.3.3.4]
b. 29 May 1861 d. 13 Aug 1924
12
Wilbur Sherman Jones
[1.1.1.1.1.1.4.2.8.3.3.5]
b. 17 Oct 1865 d. 1942
10
Hannah Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.8.4]
b. 29 Sep 1783
10
Peter Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.8.5]
b. 24 Apr 1786
9
Luke Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.9]
b. 10 Aug 1754
9
Joanna Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.10]
b. 26 Jun 1756 d. 30 Sep 1761
9
Josiah Taft
[1.1.1.1.1.1.4.2.11]
b. 1 Oct 1758 d. 29 Sep 1761
8
Peter Rawson Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3]
b. 1715 d. 12 Dec 1783
Elizabeth Cheney
b. 21 Sep 1707 d. 21 Sep 1783
9
Henry Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.1]
b. 7 Feb 1737 d. 2 Feb 1812
Sarah Howe
b. 14 Apr 1742 d. 26 Jun 1789
10
Joel Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.1.1]
b. 7 Nov 1763 d. 10 Oct 1855
Polly Earle
b. 28 Mar 1774 d. 1864
11
Martha Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.1.1.1]
b. 24 Dec 1802 d. Bef 1860
11
Emons Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.1.1.2]
b. 7 Apr 1804
11
Lewis Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.1.1.3]
b. 1814 d. Bef 1860
Mary Ann Stone
b. 22 Mar 1818 d. 27 Feb 1899
12
Fayette L Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.1.1.3.1]
b. Abt 1843
12
Hannah Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.1.1.3.2]
b. Abt 1845
11
Rufus Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.1.1.4]
b. 18 Mar 1817 d. Bef 1860
11
Roxana Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.1.1.5]
b. 14 Dec 1819 d. Bef 1860
10
Peter Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.1.2]
b. 11 Jan 1773
Phebe Wheaton
b. 28 May 1771
11
Phebe Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.1.2.1]
b. 15 Jan 1809 d. 12 Mar 1849
Cyrus Hodges
b. 1 Apr 1803 d. 1 Mar 1873
12
Adonijah White Hodges
[1.1.1.1.1.1.4.3.1.2.1.1]
b. 9 Aug 1827 d. 18 Apr 1828
12
Henry Francisco Hodges
[1.1.1.1.1.1.4.3.1.2.1.2]
b. 20 Oct 1828
12
Harry Sylvanies Hodges
[1.1.1.1.1.1.4.3.1.2.1.3]
b. 20 Oct 1828 d. 20 Nov 1828
12
Seth Blowers Hodges
[1.1.1.1.1.1.4.3.1.2.1.4]
b. 18 Mar 1831 d. 20 May 1907 [
=>
]
12
George Luther Hodges
[1.1.1.1.1.1.4.3.1.2.1.5]
b. 6 Aug 1833 d. 14 Sep 1833
12
Orlin Chapman Hodges
[1.1.1.1.1.1.4.3.1.2.1.6]
b. 28 Aug 1835 d. 19 May 1836
12
Amos Van Buren Hodges
[1.1.1.1.1.1.4.3.1.2.1.7]
b. 25 Apr 1838 d. 1 Nov 1849
12
Phebe Alice Hodges
[1.1.1.1.1.1.4.3.1.2.1.8]
b. 2 Oct 1840 d. 11 Nov 1849
12
Sarah Salina Hodges
[1.1.1.1.1.1.4.3.1.2.1.9]
b. 14 Dec 1842 d. 18 Nov 1849
12
June Hodges
[1.1.1.1.1.1.4.3.1.2.1.10]
b. 7 Jul 1846 d. 15 Jul 1846
12
John Hodges
[1.1.1.1.1.1.4.3.1.2.1.11]
b. 7 Jul 1846 d. 19 Jul 1846
10
Lydia Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.1.3]
b. 15 Oct 1766 d. 28 Jul 1786
10
Amos Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.1.4]
b. 26 Aug 1768 d. 6 Aug 1789
10
Sarah Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.1.5]
b. 18 Jan 1771 d. 22 Feb 1792
10
Caleb Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.1.6]
b. 2 Apr 1775 d. 26 Oct 1840
Lois Carleton
b. Abt 1776
11
Lois Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.1.6.1]
b. 10 Mar 1801
11
Rhoda Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.1.6.2]
b. 20 Oct 1802
11
Calvin Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.1.6.3]
b. 11 Dec 1804
11
Lydia Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.1.6.4]
b. 30 Apr 1806
11
Nancy Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.1.6.5]
b. 19 Sep 1809
11
Dudley Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.1.6.6]
b. 6 Nov 1811
Calista Anne Dodge
b. 14 Nov 1817
12
George Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.1.6.6.1]
b. Abt 1841
12
Helen Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.1.6.6.2]
b. Abt 1844
12
Elbridge Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.1.6.6.3]
b. Abt 1847 [
=>
]
12
John E. Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.1.6.6.4]
b. Abt 1849
12
Henry Edgar Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.1.6.6.5]
b. 12 Apr 1856 d. 7 Sep 1927 [
=>
]
11
Daniel Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.1.6.7]
b. 21 Dec 1815
10
Abisha Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.1.7]
b. 15 Jun 1777
Mary Bliss
d. 1 Feb 1822
11
Tryphina Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.1.7.1]
b. 29 Jun 1810 d. 13 Oct 1849
11
Clarissa Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.1.7.2]
b. 1817 d. 24 Dec 1840
11
Denison Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.1.7.3]
b. 6 Jun 1819
Louisa Mary Gale
b. 5 Oct 1818 d. 15 Jun 1853
12
John A Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.1.7.3.1]
b. 8 Jul 1845
12
Clara L Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.1.7.3.2]
b. 24 Feb 1847 d. Jan 1867
12
Lucius D Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.1.7.3.3]
b. 1 Dec 1852
+
Sally Sprague
10
David Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.1.8]
b. 13 Aug 1779
9
Gershom Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.2]
b. 20 Oct 1739 d. 29 Apr 1813
Abigail Reed
b. 12 Dec 1736 d. 24 Feb 1816
10
Calvin Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.2.1]
b. 17 Nov 1765 d. 12 Feb 1816
Molley
b. 1755 d. 12 Feb 1847
11
Newell Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.2.1.1]
b. 13 Feb 1788
11
Benjamin Clark Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.2.1.2]
b. 17 May 1790
11
Chandler Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.2.1.3]
b. 29 May 1792
Abigail Taft
b. 24 Jan 1791 d. 15 May 1837
12
Augustine Calvin Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.2.1.3.1]
b. 11 May 1817 [
=>
]
11
Ohila Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.2.1.4]
b. 25 Mar 1796
11
Mellen Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.2.1.5]
b. 18 Oct 1799 d. 3 Jun 1839
11
Mary Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.2.1.6]
b. 25 Aug 1803 d. 20 Feb 1816
11
Eliza Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.2.1.7]
b. 20 Jun 1805
11
James Whitman Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.2.1.8]
b. 21 Jan 1809 d. 8 Aug 1834
10
Elisabeth Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.2.2]
b. 13 May 1769 d. Bef 1871
10
Cheney Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.2.3]
b. 3 May 1771 d. 27 Jun 1838
10
Ruth Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.2.4]
b. 23 Feb 1773
10
Phila Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.2.5]
b. 4 Jul 1775 d. 29 Sep 1776
10
Reed Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.2.6]
b. 13 Mar 1780
9
Peter Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.3]
b. 26 Aug 1741 d. 13 Sep 1802
+
Mercy Corpe
b. 11 Dec 1732
9
Aaron Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.4]
b. 28 May 1743 d. 26 Mar 1808
Rhoda Rawson
b. 4 Oct 1749 d. 9 Jun 1827
10
Millie Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.1]
b. 29 Jul 1769
Ezekiel Clark
b. 13 Apr 1766
11
Willard Boyd Clark
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.1.1]
b. 18 May 1792
11
William B Clark
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.1.2]
b. 15 Apr 1793 d. 27 Apr 1818
11
Lucis Clark
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.1.3]
b. 4 Sep 1795
11
Lewis C Clark
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.1.4]
b. 6 Sep 1795 d. 16 Jan 1831
11
Maria Clark
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.1.5]
b. 12 Jul 1798
+
Jacob Bryant
11
Franklin Clark
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.1.6]
b. 13 Dec 1801 d. 1 Feb 1846
11
Charles T Clark
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.1.7]
b. 8 Apr 1804
10
Selina Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.2]
b. 20 Feb 1771 d. 22 Sep 1838
Jesse Ensign Murdock
b. 13 Sep 1762 d. 11 May 1850
11
Judson Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.2.1]
b. 24 Aug 1794 d. 26 Jun 1877
Judith Brigham Murdock
b. 10 Oct 1797 d. 8 Jun 1881
12
Cornelia Maria Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.2.1.1]
b. 17 Dec 1817 d. 14 Dec 1882 [
=>
]
12
Ann L Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.2.1.2]
b. 1819 d. Dec 1819
12
Louise Jane Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.2.1.3]
b. 23 Jun 1823 d. 6 Jun 1841
12
Candace J Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.2.1.4]
b. 1825 d. 7 Aug 1877 [
=>
]
12
Oscar Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.2.1.5]
b. 24 Nov 1827 d. 7 Jun 1858
12
Harriet Elizabeth Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.2.1.6]
b. 1830 d. 7 Oct 1902
12
Henry Judson Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.2.1.7]
b. 8 Dec 1831 d. 23 Mar 1899 [
=>
]
12
Frances Isabelle Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.2.1.8]
b. 22 Nov 1833 d. 15 Dec 1918 [
=>
]
11
Harriet Fuller Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.2.2]
b. 17 Nov 1798 d. 5 May 1838
Phineas Wood
b. 18 Apr 1800 d. 10 Apr 1866
12
Daughter Wood
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.2.2.1]
b. 1831 d. 24 Aug 1831
12
Charles Phineas Wood
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.2.2.2]
b. 3 Aug 1837 d. 30 Aug 1849
11
Selina Fuller Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.2.3]
b. 24 Dec 1803 d. 19 Apr 1860
Nathaniel Whitcomb Powers
b. 23 Feb 1806 d. 16 Jul 1878
12
Selina Murdock Powers
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.2.3.1]
b. 19 Mar 1846 d. 10 Aug 1932 [
=>
]
11
Eliza Taft Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.2.4]
b. 8 Mar 1808 d. Bef 1812
11
Eliza Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.2.5]
b. 31 Jul 1812
10
Cynthia Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.3]
b. 17 Aug 1773
Nathaniel Butler
b. 1769
11
Cynthia M Butler
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.3.1]
b. 12 Aug 1802 d. 24 Jan 1875
11
George T Butler
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.3.2]
b. 24 Nov 1804 d. 5 Nov 1841
Esther Stone
b. Abt 1806
12
Harvey Butler
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.3.2.1]
b. 11 Nov 1832 d. 20 Feb 1834
12
Rawson Butler
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.3.2.2]
b. 1 Dec 1834
12
Lewis Alphonse Butler
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.3.2.3]
b. 5 Nov 1838
11
Rawson A Butler
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.3.3]
b. 8 Jun 1806 d. 9 Sep 1865
Pamelia Mathews
b. Abt 1817
12
Henry Taft Butler
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.3.3.1]
b. 20 Dec 1840 d. 24 Oct 1869
12
Mary E Butler
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.3.3.2]
b. 5 Jul 1842 d. 22 Aug 1859
12
Cynthia M Butler
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.3.3.3]
b. 24 May 1844
12
George M Butler
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.3.3.4]
b. 10 Dec 1846
12
Edward E Butler
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.3.3.5]
b. 1 May 1849 [
=>
]
12
Frank C Butler
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.3.3.6]
b. 28 Jul 1852 d. 2 Dec 1859
11
Marian Butler
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.3.4]
b. 19 Mar 1809
Rev Elijah Buck
b. 1 Mar 1799 d. 17 Aug 1889
12
Henry Dwight Buck
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.3.4.1]
b. 7 Mar 1834
12
Cynthia Ann Buck
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.3.4.2]
b. 4 Mar 1836
12
Francis Mary Buck
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.3.4.3]
b. 29 Jul 1839 d. 11 Nov 1839
12
Edward Rawson Buck
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.3.4.4]
b. 9 Jan 1842
12
George Nathaniel Buck
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.3.4.5]
b. 15 Aug 1846 [
=>
]
12
Charles Buck
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.3.4.6]
b. 26 Jan 1848 d. 26 Apr 1848
12
Mary Harriett Buck
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.3.4.7]
b. 18 Aug 1849
12
Charles Butler Buck
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.3.4.8]
b. 23 Dec 1851
10
Polly Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.4]
b. 18 Sep 1777 d. 29 Aug 1816
Hezediah Murdock
b. 30 Jun 1776 d. 17 Aug 1864
11
Bazaleel White Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.4.1]
b. 22 Nov 1798 d. 6 Aug 1809
11
Polly Taft Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.4.2]
b. 28 Mar 1803 d. 26 Nov 1846
William Bond
b. 25 May 1796 d. 7 Jul 1838
12
Polly Bond
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.4.2.1]
b. Abt 1822
12
Laura Bond
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.4.2.2]
b. Abt 1824
12
Harriet Bond
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.4.2.3]
b. Abt 1826
12
Lucretia Bond
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.4.2.4]
b. 24 Jul 1826 d. 1883 [
=>
]
12
Orvil Bond
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.4.2.5]
b. Abt 1830
12
Caroline Bond
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.4.2.6]
b. 1 Jul 1831 d. 30 Apr 1909 [
=>
]
12
Charles William Bond
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.4.2.7]
b. 17 Jun 1834 [
=>
]
12
Frances Mary Bond
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.4.2.8]
b. 11 Jan 1837 d. Abt 1873 [
=>
]
11
Stephen Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.4.3]
b. 4 Mar 1801 d. 29 Dec 1889
Eunice Dix
b. 18 Sep 1807 d. 20 Feb 1888
12
Stephen Albert Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.4.3.1]
b. 2 Dec 1830 d. 18 Mar 1835
12
Charles Hrney Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.4.3.2]
b. 30 Mar 1832 d. 18 Nov 1832
12
Eunice Elizabeth Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.4.3.3]
b. 8 Oct 1833 d. 3 Mar 1835
12
Albert S Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.4.3.4]
b. 3 Nov 1834 d. 23 Sep 1915 [
=>
]
12
Edwin Frances Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.4.3.5]
b. 22 Aug 1836 d. 12 Dec 1837
12
Eunice Elizabeth Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.4.3.6]
b. 2 Jan 1840 d. 19 Oct 1882
12
Clarissa Jane Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.4.3.7]
b. 5 Feb 1842 d. 2 Jan 1913
12
Edwin Frances Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.4.3.8]
b. 9 Apr 1844
12
Henry Prescott Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.4.3.9]
b. 13 Jan 1846 d. 4 Jul 1892
12
Frederick Eugene Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.4.3.10]
b. 7 Sep 1847 d. 13 Nov 1899
12
Ella Medora Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.4.3.11]
b. 2 Jan 1852
11
Levi Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.4.4]
b. Abt 1802
11
John Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.4.5]
b. 2 Nov 1806 d. 8 Dec 1891
Mary Cummings
b. 7 Dec 1809 d. 17 Jun 1890
12
Martha Cummings Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.4.5.1]
b. 23 Aug 1841 d. 17 Jan 1873
12
John Grosvenor Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.4.5.2]
b. 2 Apr 1843 d. 22 Feb 1905
12
Adna Cummings Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.4.5.3]
b. 15 Nov 1844 d. 11 Aug 1907
11
Sylvia Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.4.6]
b. 28 Feb 1808 d. 23 Dec 1885
Alvin Cowles
b. Abt 1797
12
Hattie A. Cowles
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.4.6.1]
b. 13 Jan 1833 d. 3 Nov 1913
12
Ellen Cowles
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.4.6.2]
b. 1837 d. 29 Sep 1898 [
=>
]
11
Grosvenor Taft Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.4.7]
b. 29 May 1814 d. 23 Dec 1891
+
Laura Ann Harris
11
Son Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.4.8]
b. 1816 d. 25 May 1816
11
Benjamin Read Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.4.9]
b. 20 Aug 1817 d. 20 Oct 1842
Clarinda Gilmore
b. 1815 d. 16 Sep 1905
12
William Hezekiah Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.4.9.1]
b. 5 May 1841 d. 10 Nov 1920 [
=>
]
11
Sophia Murdock
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.4.10]
b. 31 Aug 1819 d. 21 Oct 1889
Orin Gilmore
b. 1812 d. 26 Apr 1881
12
Kelsey Murdock Gilmore
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.4.10.1]
b. 29 Aug 1840 d. Abt 1909 [
=>
]
12
A. B. Gilmore
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.4.10.2]
b. 22 Aug 1843
10
Zeruiah Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.5]
b. 21 Nov 1779 d. 21 Oct 1852
Major Willard Lovell
b. 1782 d. 1839
11
Lucia Lovell
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.5.1]
b. 19 May 1808
11
Mary Malgretta Lovell
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.5.2]
b. 6 Dec 1809 d. 1857
John Foster Gilkey
b. 1803 d. 8 Aug 1878
12
Edgar H Gilkey
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.5.2.1]
b. Abt 1841
12
Patrick Henry Gilkey
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.5.2.2]
b. Abt 1843 [
=>
]
12
Lucien Gilkey
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.5.2.3]
b. Abt 1845
12
Julian F Gilkey
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.5.2.4]
b. Apr 1850
11
Cynthia Ann Lovell
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.5.3]
b. 29 Apr 1811 d. Bef 1861
11
Elizabeth Adeline Lovell
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.5.4]
b. 4 Mar 1815 d. 29 Aug 1818
11
George Lovell
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.5.5]
b. 9 Dec 1818
11
Enos Lovell
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.5.6]
b. 22 Jul 1821 d. 16 Sep 1821
11
Lafayette Lovell
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.5.7]
b. 27 May 1823
10
Mary Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.6]
b. 12 Jul 1783 d. 7 Feb 1839
+
Nathaniel Stiles
b. 22 Jun 1777 d. 1829
10
Peter Rawson Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.7]
b. 14 Apr 1785 d. 1 Jan 1867
Sylvia Howard
b. 1 Feb 1792 d. 1886
11
Alphonso Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.7.1]
b. 5 Nov 1810 d. 21 May 1891
Fannie Phelps
b. 28 Mar 1823 d. 2 Jun 1851
12
Son Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.7.1.1]
b. 1842 d. 1842
12
Charles P Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.7.1.2]
b. 21 Dec 1842 d. 21 Dec 1929
12
Peter Rawson Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.7.1.3]
b. 10 May 1846 d. 1888 [
=>
]
12
Mary Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.7.1.4]
b. 1848 d. 1848
12
Alphonso Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.7.1.5]
b. 1850 d. 1851
Louisa Maria Torrey
b. 11 Sep 1827 d. 8 Dec 1907
12
Samuel Davenport Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.7.1.6]
b. 7 Feb 1855 d. 1855
12
President William Howard Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.7.1.7]
b. 15 Sep 1857 d. 8 Mar 1930 [
=>
]
12
Henry Waters Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.7.1.8]
b. 27 May 1859 d. 11 Aug 1945 [
=>
]
12
Horace Dutton Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.7.1.9]
b. 28 Sep 1861 d. 28 Jan 1943
12
Alphonso Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.7.1.10]
b. 1865
12
Frances Louise Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.7.1.11]
b. 18 Jul 1865 d. 4 Jan 1950
10
Sophia Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.8]
b. 30 Dec 1787 d. 27 Nov 1843
10
Samuel Judson Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.9]
b. 6 Nov 1791 d. 9 Jun 1867
Lucy C Hayward
b. 1795 d. 21 Dec 1862
11
Sophia Amelia Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.9.1]
d. 12 Dec 1900
George Ropes
b. Mar 1831
12
Ella Elson Ropes
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.9.1.1]
b. 1864
12
Alice Hayward Ropes
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.9.1.2]
b. Feb 1866
12
George H Ropes
[1.1.1.1.1.1.4.3.4.9.1.3]
b. 14 Aug 1868
9
Thankful Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.5]
b. 25 May 1745 d. 26 Oct 1837
Stephen Sibley
b. 12 Jul 1741 d. 25 Aug 1828
10
Joel Sibley
[1.1.1.1.1.1.4.3.5.1]
b. 25 Apr 1766 d. 10 Apr 1839
Lois Louise Woods
b. 24 Jun 1767 d. 21 Nov 1832
11
Amory Sibley
[1.1.1.1.1.1.4.3.5.1.1]
b. 20 Jun 1792 d. 22 Jun 1849
Caroline Bosworth
b. Abt 1796 d. 13 Jan 1858
12
Martha Elmira Sibley
[1.1.1.1.1.1.4.3.5.1.1.1]
b. 16 Oct 1839 d. 1 Oct 1920 [
=>
]
11
Josiah Sibley
[1.1.1.1.1.1.4.3.5.1.2]
b. 1 Apr 1808 d. 7 Dec 1888
Sarah Ann Sophia Crapon
b. 24 Oct 1809 d. 17 May 1858
12
Samuel Hale Sibley
[1.1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.1]
b. 9 Sep 1835 d. 1883 [
=>
]
12
William Crapon Sibley
[1.1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.2]
b. 3 May 1832 d. 17 Apr 1902 [
=>
]
12
Henry Josiah Sibley
[1.1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.3]
b. 19 Nov 1833 d. 25 Jul 1864
12
Sophia Matilda Sibley
[1.1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.4]
b. 16 Oct 1837 d. 29 Oct 1897
12
George Royal Sibley
[1.1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.5]
b. 19 Jul 1839 d. 15 Jul 1895 [
=>
]
12
Fannie Maria Sibley
[1.1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.6]
b. 13 Oct 1841 d. 20 Dec 1842
12
Mary Lois Sibley
[1.1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.7]
b. 3 Sep 1843 d. 23 Feb 1864
12
Alice Marie Sibley
[1.1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.8]
b. 9 Feb 1846 d. 13 Jul 1907
12
Robert Pendelton Sibley
[1.1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.9]
b. Abt 1847 [
=>
]
12
Caroline Crapon Sibley
[1.1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.10]
b. 21 Feb 1850 d. 16 Nov 1858
12
Amory Walter Sibley
[1.1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.11]
b. 19 Jun 1852 d. 28 Jul 1899
12
Josiah Sibley
[1.1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.12]
b. 1866 d. 1879
Emaline Eve
b. 1839
12
John Adam Sibley
[1.1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.13]
b. 1 Sep 1861 d. 26 Mar 1934
12
James Longstreet Sibley
[1.1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.14]
b. 4 Aug 1863 d. 10 Sep 1945 [
=>
]
12
Mary Bones Sibley
[1.1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.15]
b. 29 Mar 1865 d. 22 Jun 1954
12
Emma Josephine Sibley
[1.1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.16]
b. 23 Feb 1867 d. 25 Oct 1957 [
=>
]
10
Lydia Sibley
[1.1.1.1.1.1.4.3.5.2]
b. 2 Apr 1769 d. 27 Nov 1822
Henry Staples Benson
b. 8 Aug 1770 d. 29 Jul 1821
11
Abigail Benson
[1.1.1.1.1.1.4.3.5.2.1]
b. 31 Mar 1795 d. 10 Nov 1821
Asa Legg
b. 7 May 1792 d. 15 Nov 1836
12
Charlotte Legg
[1.1.1.1.1.1.4.3.5.2.1.1]
b. 2 May 1818 d. 30 Oct 1900 [
=>
]
12
Lyman Legg
[1.1.1.1.1.1.4.3.5.2.1.2]
b. 3 Sep 1822 d. 1 Sep 1904 [
=>
]
11
Harriet Benson
[1.1.1.1.1.1.4.3.5.2.2]
b. 14 Sep 1796 d. 22 Aug 1852
11
Mellen Benson
[1.1.1.1.1.1.4.3.5.2.3]
b. 14 Jan 1798
Eliza W Farnum
b. 25 Sep 1802 d. 14 Sep 1839
12
Henry Staples Benson
[1.1.1.1.1.1.4.3.5.2.3.1]
b. 17 May 1829
12
Almira Farnum Benson
[1.1.1.1.1.1.4.3.5.2.3.2]
b. 6 Aug 1830 d. 25 Dec 1835
12
James Haskins Benson
[1.1.1.1.1.1.4.3.5.2.3.3]
b. 16 Oct 1833
12
George Everett Benson
[1.1.1.1.1.1.4.3.5.2.3.4]
b. 14 Aug 1837
+
Mary Windsor Peck
b. 21 May 1798
11
Hannah Adaline Benson
[1.1.1.1.1.1.4.3.5.2.4]
b. 12 Aug 1802 d. 19 Jun 1822
11
Rufus Benson
[1.1.1.1.1.1.4.3.5.2.5]
b. 24 Jan 1804 d. 23 Aug 1805
11
Chloe Ann Benson
[1.1.1.1.1.1.4.3.5.2.6]
b. 23 Aug 1806
+
Dan Hill
b. 29 Nov 1796
11
Susan Augusta Benson
[1.1.1.1.1.1.4.3.5.2.7]
b. 9 Oct 1809 d. 25 Jul 1831
Preserved Smith Thayer
b. 9 May 1808
12
Susan Benson Thayer
[1.1.1.1.1.1.4.3.5.2.7.1]
b. 28 Jun 1831 d. 14 Aug 1909
11
Rufus Aldrich Benson
[1.1.1.1.1.1.4.3.5.2.8]
b. 9 Oct 1809
+
Sarah E Buell
11
Stephen Sibley Benson
[1.1.1.1.1.1.4.3.5.2.9]
b. 9 Jan 1810 d. 20 Nov 1869
Elizabeth Richardson Scott
b. 8 Jan 1835 d. 20 Feb 1911
12
Jessie Harriet Benson
[1.1.1.1.1.1.4.3.5.2.9.1]
b. 7 Jun 1860
12
Fred Mellen Benson
[1.1.1.1.1.1.4.3.5.2.9.2]
b. 10 Nov 1862 d. 9 May 1864
12
Susie Adeline Benson
[1.1.1.1.1.1.4.3.5.2.9.3]
b. 6 Aug 1865
9
Joel Taft
[1.1.1.1.1.1.4.3.6]
b. 28 May 1747 d. 27 Sep 1758
8
Sarah Taft
[1.1.1.1.1.1.4.4]
b. 9 Mar 1719
8
Captain Joseph Taft
[1.1.1.1.1.1.4.5]
b. 19 Apr 1722 d. 25 Dec 1787
Elizabeth Thayer
b. 13 Feb 1724 d. 27 Aug 1797
9
Rueben Taft
[1.1.1.1.1.1.4.5.1]
b. 21 Oct 1742 d. Aft 1761
Faithful Thayer
b. 18 Jun 1744 d. 1827
10
Susannah Taft
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.1]
b. 27 Dec 1761 d. 14 Nov 1825
Isaac Dresser
b. 22 Feb 1759 d. 4 Dec 1835
11
Reuben Dresser
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.1.1]
b. 11 Jun 1781 d. 5 Sep 1782
11
Betsey Dresser
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.1.2]
b. 22 May 1783
11
Polly Dresser
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.1.3]
b. 14 Jun 1785
11
Leonard Dresser
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.1.4]
b. 7 Aug 1787 d. 26 Apr 1838
Mary Thombs
b. 25 Dec 1790 d. 27 Aug 1866
12
Clarissa Codelia Dresser
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.1.4.1]
b. 8 Nov 1812
12
Joseph Western Dresser
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.1.4.2]
b. 7 Jun 1814
12
Leonard Augustus Dresser
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.1.4.3]
b. 1 Dec 1815 d. 27 Jun 1875 [
=>
]
12
Mary Diana Dresser
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.1.4.4]
b. 6 Dec 1817 d. 30 Nov 1833
12
Sarah Diana Dresser
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.1.4.5]
b. 21 Mar 1819 [
=>
]
12
Emily Dresser
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.1.4.6]
b. 25 Dec 1821 d. 25 Dec 1900 [
=>
]
12
James Volna Dresser
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.1.4.7]
b. 2 Mar 1823 d. 18 Jun 1826
12
Electa Dresser
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.1.4.8]
b. 18 Aug 1825
12
Eliza Jane Dresser
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.1.4.9]
b. 30 Apr 1827 [
=>
]
12
Louisa Dresser
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.1.4.10]
b. 27 Oct 1830 d. 8 Dec 1907 [
=>
]
12
John Quincy Dresser
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.1.4.11]
b. 20 Sep 1832 d. 16 Apr 1918 [
=>
]
11
Clarissa Dresser
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.1.5]
b. 4 Sep 1789 d. 5 Aug 1867
Roderick Random Stewart
b. 25 Feb 1787 d. 12 Jul 1860
12
Isaac Newton Stewart
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.1.5.1]
b. 12 Oct 1814 d. 23 Apr 1883
12
Narcissa Random Stewart
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.1.5.2]
b. 25 Feb 1816 d. 17 Mar 1850
12
Elisha Milton Stewart
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.1.5.3]
b. 28 Jun 1818 d. 3 Jul 1899 [
=>
]
12
Susannah Dresser Stewart
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.1.5.4]
b. 28 Jan 1820 d. 8 Jun 1889 [
=>
]
12
Permelia Taft Stewart
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.1.5.5]
b. 7 Jun 1822 d. 4 Dec 1897 [
=>
]
12
La Fayette Stewart
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.1.5.6]
b. 21 Jun 1824 d. 17 Jun 1898 [
=>
]
12
Josiah Taft Stewart
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.1.5.7]
b. 6 Oct 1828 d. 1 Jan 1855
12
George Washington Stewart
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.1.5.8]
b. 27 Jan 1830 d. 20 Feb 1902 [
=>
]
11
Susanna Dresser
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.1.6]
b. 3 Nov 1791
+
Jonathan Gould
b. Abt 1788
11
Isaac Dresser
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.1.7]
b. 19 May 1793 d. 5 Feb 1862
Laura Frary
b. 2 Nov 1802 d. Aug 1858
12
James Munroe Dresser
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.1.7.1]
b. 6 Dec 1820 d. 13 Nov 1833
12
Justus Frary Dresser
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.1.7.2]
b. 21 Nov 1822 d. 1824
12
Justus Frary Dresser
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.1.7.3]
b. 7 Nov 1825 d. 1 Jan 1881 [
=>
]
12
Theda Dresser
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.1.7.4]
b. 9 Sep 1827 d. 31 Oct 1895
12
Clarissa Susannah Dresser
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.1.7.5]
b. 30 Nov 1832 d. 20 Jan 1852
12
Eliza Rebecca Dresser
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.1.7.6]
b. 7 Feb 1841 d. 9 Sep 1843
+
Emily Marcy
b. Abt 1805
11
Diana Dresser
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.1.8]
b. 17 Dec 1795
11
David Dresser
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.1.9]
b. 12 Sep 1797
Dorcas Williams
b. 18 Apr 1794
12
Gilbert W Dresser
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.1.9.1]
b. Abt 1819 d. 17 Jul 1856 [
=>
]
10
Nancy Taft
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.2]
b. 9 Jul 1763 d. 1835
10
Rhoxanna Taft
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.3]
b. 14 Aug 1765 d. 1837
+
Josiah Wood
10
Diana Taft
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.4]
b. 4 Sep 1767 d. 1830
+
Silvanus Thayer
b. 4 Sep 1762
10
Joseph Taft
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.5]
b. 26 Jun 1769
10
Marcy Taft
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.6]
b. 11 Aug 1771 d. 1840
10
Polly Taft
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.7]
b. 9 Jun 1773 d. 26 Oct 1848
Jesse Hurlbut
b. 21 Jul 1769 d. 11 Jan 1848
11
Polly Hurlbut
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.7.1]
b. 27 Apr 1793 d. 17 Sep 1861
John William Wilcox
b. 8 Jun 1793 d. 17 Sep 1861
12
Stephen Dorman Wilcox
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.7.1.1]
b. Abt 1815 d. 22 Jan 1863 [
=>
]
12
Roxana Wilcox
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.7.1.2]
b. Abt 1817 d. 1820
12
Montreville Russell Wilcox
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.7.1.3]
b. 4 Sep 1826 d. 13 Jan 1888 [
=>
]
11
Reuben Hurlbut
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.7.2]
b. 7 Apr 1794 d. 28 May 1879
Hannah Moore
b. 1794 d. 18 Nov 1861
12
Diana S Hurlbut
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.7.2.1]
b. 12 Nov 1816
12
Polly A Hurlbut
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.7.2.2]
b. 27 Nov 1818
12
Sarah Ann Hurlburt
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.7.2.3]
b. 26 Jul 1820 d. 23 Apr 1908 [
=>
]
12
Chauncey Hurlbut
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.7.2.4]
b. 7 Nov 1822
12
Marmary Annette Hurlbut
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.7.2.5]
b. 12 Sep 1824 d. 14 May 1914
12
Edwin Taft Monroe Hurlbut
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.7.2.6]
b. 20 Jun 1828 [
=>
]
12
Iantha C Hurlbut
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.7.2.7]
b. 31 May 1826
12
Seth Hurlbut
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.7.2.8]
b. 12 Jul 1833
12
Sylvia Hurlbut
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.7.2.9]
b. 7 Feb 1836
11
Aseneth Hurlbut
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.7.3]
b. 7 Jan 1797 d. 26 May 1875
Bechias Dustin
b. 5 Oct 1793 d. 6 Nov 1874
12
David Dustin
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.1]
b. 15 Feb 1817 d. 25 Jun 1893 [
=>
]
12
Fornatus Dustin
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.2]
b. 17 Feb 1820 d. 11 Oct 1872 [
=>
]
12
Bechias Dustin
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.3]
b. 21 Oct 1823 d. Aft 1870
12
Seth Dustin
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.4]
b. 21 Oct 1825 d. 2 Dec 1903 [
=>
]
12
Joseph Dustin
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.5]
b. 15 Dec 1827 d. 10 Dec 1914 [
=>
]
12
Aseneth Cecilia Dustin
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.6]
b. 25 Feb 1829 d. Mar 1899 [
=>
]
12
Roxanna Mahalia Dustin
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.7]
b. 3 Jul 1833 d. 11 Mar 1903 [
=>
]
12
Franklin Dustin
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.8]
b. 1834 d. Aft 1885
12
Christopher Dustin
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.9]
b. 1837 d. 12 Aug 1898
12
Andrew Dustin
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.10]
d. Bef 1845
11
Diana Hurlbut
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.7.4]
b. 29 Mar 1798 d. 1 Mar 1841
+
George Fox
b. 1794
11
Alma Hurlbut
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.7.5]
b. 13 Feb 1800
+
Reed
b. Abt 1796
11
Hiram Higgins Hurlbut
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.7.6]
b. 29 Nov 1801 d. 20 Jul 1864
Lydia McIntyre
b. 18 Aug 1805
12
Mary Hurlbut
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.7.6.1]
b. 27 Jun 1826 d. 7 Jul 1865
12
Sarah Hurlbut
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.7.6.2]
b. 2 Sep 1827
12
Esther Mahala Hurlburt
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.7.6.3]
b. 20 Jan 1829
12
Jesse Hurlbut
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.7.6.4]
b. 13 Nov 1830 d. 25 Jul 1874 [
=>
]
12
Matilda Hurlbut
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.7.6.5]
b. 7 Jun 1832
12
Urilla Hurlbut
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.7.6.6]
b. 20 Mar 1834
12
Stephen Hulbert
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.7.6.7]
b. 28 Dec 1836 d. 1882 [
=>
]
12
Lydia Hurlbut
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.7.6.8]
b. 5 May 1838
12
Hiram Hurlbut
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.7.6.9]
b. 6 Aug 1840
12
John William Hurlbut
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.7.6.10]
b. 28 Feb 1843 [
=>
]
11
Horatio Hurlbut
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.7.7]
b. 9 Nov 1806 d. 1890
Sabrina Lumbard
b. 1 Sep 1812
12
Vincent Lumbard Hurlbut
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.7.7.1]
b. 28 Jan 1829
11
Quartus Ovando Hurlbut
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.7.8]
b. 7 Feb 1804 d. 10 Jan 1879
+
Hetty Dann
b. Abt 1808
10
Ruth Taft
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.8]
b. 5 Jul 1778 d. 1860
William Smith
b. Abt 1779
11
Thomas Smith
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.8.1]
b. Abt 1803 d. 21 Feb 1884
10
Betsy Taft
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.9]
b. 24 Mar 1776 d. Feb 1853
Moses Chapin
b. 24 May 1776 d. 19 Jul 1844
11
Joseph Chapin
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.9.1]
b. 15 Jul 1797 d. 12 Jun 1857
Louisa Veaux
b. Abt 1801
12
Sarah Chapin
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.9.1.1]
b. 3 Dec 1825
12
Caroline Chapin
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.9.1.2]
c. 14 Aug 1828 d. 20 Aug 1843
Harriet Elizabeth Voax
b. 18 Jul 1821 d. 23 Sep 1872
12
Joseph Chapin
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.9.1.3]
b. 6 May 1845 d. 22 Aug 1846
12
Harriet Louise Chapin
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.9.1.4]
b. 9 Mar 1848
12
Ann Elizabeth Chapin
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.9.1.5]
b. 10 Feb 1851 d. 22 Jun 1853
11
Stephen Chapin
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.9.2]
b. 4 Jan 1801 d. 9 Mar 1843
Julia Emily Taft
b. 1807
12
Moses Williams Chapin
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.9.2.1]
b. 10 Jun 1829 d. 7 May 1884 [
=>
]
11
Ruth Adaline Chapin
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.9.3]
b. 24 Oct 1802 d. 1862
William Thornton
b. Abt 1798 d. 1862
12
Sylvia Taft Thornton
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.9.3.1]
b. 2 Jan 1833
12
William Handy Thornton
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.9.3.2]
b. 16 Jan 1837
12
John Green Thornton
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.9.3.3]
b. 11 Mar 1841
11
Orris Taft Chapin
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.9.4]
b. 27 Jan 1805 d. 20 Dec 1849
Martha Dickson
b. 9 Jan 1804 d. 16 Mar 1856
12
Thomas Rundle Chapin
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.9.4.1]
b. 11 Oct 1829 d. 24 Feb 1905 [
=>
]
12
Augustine Francis Chapin
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.9.4.2]
b. 9 Jan 1832 d. 6 Jul 1868 [
=>
]
12
Luthera Chapin
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.9.4.3]
b. Abt 1834
11
Betsy Taft Chapin
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.9.5]
b. 14 Oct 1807 d. 21 Apr 1838
Parley Gould
b. 17 Sep 1807 d. 16 Jan 1877
12
Luthera Gould
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.9.5.1]
b. 15 Jul 1833 d. 13 Oct 1862
12
Augustine Gould
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.9.5.2]
b. 18 Mar 1835 [
=>
]
11
Abigail Adams Chapin
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.9.6]
b. 4 Sep 1809 d. 6 Aug 1854
Benedict Arnold Greene
b. 17 Jan 1812 d. 12 Jan 1858
12
Robert E Greene
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.9.6.1]
b. 2 Mar 1845
12
Julia Amanda Greene
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.9.6.2]
b. 27 Feb 1847 d. Feb 1853
12
Moses Chapin Greene
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.9.6.3]
b. 15 Apr 1849 d. 1849
12
Walter Ernest Greene
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.9.6.4]
b. 1850
11
Diana Maria Chapin
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.9.7]
b. 9 Mar 1812 d. 23 Aug 1854
Richard Waterman
b. 4 Aug 1809 d. 1883
12
Abbie Maria Waterman
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.9.7.1]
b. 29 Mar 1835 d. 1906 [
=>
]
12
Louisa Chapin Waterman
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.9.7.2]
b. 23 Jul 1837 d. 25 Jul 1837
12
Elizabeth Slade Waterman
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.9.7.3]
b. 23 Jul 1837
12
Caroline Chapin Waterman
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.9.7.4]
b. 5 Dec 1844 d. 11 Mar 1848
12
John Waterman
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.9.7.5]
b. 7 Mar 1847 d. 26 Feb 1918
12
Thomas Warner Waterman
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.9.7.6]
b. 8 Jun 1849
12
Fannie Alice Waterman
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.9.7.7]
b. 24 Oct 1851 d. 21 Sep 1853
12
Frank Arthur Waterman
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.9.7.8]
b. 24 Oct 1852
11
Moses Smeadley Chapin
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.9.8]
b. 15 Aug 1816 d. 14 Nov 1819
11
Adaline Chapin
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.9.9]
b. 14 May 1820 d. 1904
9
Lucy Taft
[1.1.1.1.1.1.4.5.2]
b. 5 Mar 1745 d. 1822
9
Silas Taft
[1.1.1.1.1.1.4.5.3]
b. 22 Nov 1747
9
Sarah Taft
[1.1.1.1.1.1.4.5.4]
b. 8 Mar 1750 d. 3 May 1811
9
Asahel Taft
[1.1.1.1.1.1.4.5.5]
b. 30 Jul 1752 d. Nov 1826
Rachel Alton
b. 9 Mar 1760 d. 5 Aug 1851
10
Silas Taft
[1.1.1.1.1.1.4.5.5.1]
b. 21 Oct 1780
10
Elizabeth Taft
[1.1.1.1.1.1.4.5.5.2]
b. 17 Mar 1783
10
Rachel Taft
[1.1.1.1.1.1.4.5.5.3]
b. Abt 1785
10
Mary Taft
[1.1.1.1.1.1.4.5.5.4]
b. 1787
10
Asahel J Taft
[1.1.1.1.1.1.4.5.5.5]
b. 1792
10
Joseph Taft
[1.1.1.1.1.1.4.5.5.6]
b. 15 Jun 1794
10
Sarah Taft
[1.1.1.1.1.1.4.5.5.7]
b. 28 Feb 1797 d. 29 Sep 1879
Wheaton W Wilson
b. 5 Aug 1787 d. 13 Jan 1874
11
Wheaton Wilson
[1.1.1.1.1.1.4.5.5.7.1]
b. 10 Nov 1817 d. 17 Aug 1900
11
Mary Wilson
[1.1.1.1.1.1.4.5.5.7.2]
b. 7 Sep 1820 d. 23 Nov 1887
11
Fanny Maria Wilson
[1.1.1.1.1.1.4.5.5.7.3]
b. 12 Sep 1822 d. 1900
11
Alonzo Wilson
[1.1.1.1.1.1.4.5.5.7.4]
b. 19 Sep 1824 d. 13 Oct 1826
11
Emily Wilson
[1.1.1.1.1.1.4.5.5.7.5]
b. 7 May 1827
11
Sophia Wilson
[1.1.1.1.1.1.4.5.5.7.6]
b. 19 Jul 1829 d. 9 Apr 1919
11
Caroline Louisa Wilson
[1.1.1.1.1.1.4.5.5.7.7]
b. 4 Mar 1832 d. 11 Mar 1892
11
John Wilson
[1.1.1.1.1.1.4.5.5.7.8]
b. 26 May 1834
11
William Walter Wilson
[1.1.1.1.1.1.4.5.5.7.9]
b. 8 Sep 1836 d. 31 Jul 1839
11
Wallace Warren Wilson
[1.1.1.1.1.1.4.5.5.7.10]
b. 28 Sep 1839 d. 22 Oct 1906
Sarah A Samson
b. 6 Dec 1842 d. 30 Apr 1915
12
Clarence Wallace Wilson
[1.1.1.1.1.1.4.5.5.7.10.1]
b. Jul 1861 d. 7 Feb 1904 [
=>
]
12
Mable Wilson
[1.1.1.1.1.1.4.5.5.7.10.2]
b. 17 Mar 1865 d. 31 Mar 1873
12
William A Wilson
[1.1.1.1.1.1.4.5.5.7.10.3]
b. 2 Jul 1866 d. 21 Nov 1904 [
=>
]
12
Albert Wilson
[1.1.1.1.1.1.4.5.5.7.10.4]
b. 1870
12
Walter Gordon Wilson
[1.1.1.1.1.1.4.5.5.7.10.5]
b. 20 Dec 1873 d. 20 Mar 1914 [
=>
]
12
Everett Wilson
[1.1.1.1.1.1.4.5.5.7.10.6]
b. 20 Jul 1878 d. 7 Jan 1884
12
Lena L Wilson
[1.1.1.1.1.1.4.5.5.7.10.7]
b. 11 Oct 1883 d. 21 Dec 1883
12
Maud E Wilson
[1.1.1.1.1.1.4.5.5.7.10.8]
b. 1886 d. 24 Jan 1907 [
=>
]
10
Fannie Taft
[1.1.1.1.1.1.4.5.5.8]
b. 14 Jan 1801 d. 3 Sep 1867
10
Emily Taft
[1.1.1.1.1.1.4.5.5.9]
b. 8 Mar 1803
9
Ezra Taft
[1.1.1.1.1.1.4.5.6]
b. 22 Dec 1752 d. Aft 1803
9
Ruth Taft
[1.1.1.1.1.1.4.5.7]
b. 13 May 1763
8
Elizabeth Taft
[1.1.1.1.1.1.4.6]
b. 30 Oct 1724
Jonathan Penniman
b. 30 Jul 1719 d. 18 Jul 1747
9
Jonathan Peniman
[1.1.1.1.1.1.4.6.1]
b. 21 Mar 1744 d. 2 Sep 1761
9
Mary Peniman
[1.1.1.1.1.1.4.6.2]
b. 27 Oct 1746 d. 5 Jul 1749
9
Ann Peniman
[1.1.1.1.1.1.4.6.3]
b. 26 Aug 1749
9
Adna Penniman
[1.1.1.1.1.1.4.6.4]
b. 5 Oct 1752 d. 4 Nov 1820
9
Bethiah Peniman
[1.1.1.1.1.1.4.6.5]
b. 12 Nov 1758
9
Nathan Peniman
[1.1.1.1.1.1.4.6.6]
b. 26 Nov 1766 d. 11 Jun 1831
8
Aaron Taft
[1.1.1.1.1.1.4.7]
b. 12 Apr 1727 d. 5 Nov 1805
Marcy Arnold
b. 24 Jan 1733 d. 22 Jan 1806
9
Rhoda Taft
[1.1.1.1.1.1.4.7.1]
b. 4 Feb 1753 d. 4 Apr 1837
9
Arnold Taft
[1.1.1.1.1.1.4.7.2]
b. 4 May 1756
9
Thaddeus Taft
[1.1.1.1.1.1.4.7.3]
b. 13 Dec 1757 d. 5 Sep 1831
9
Patiance Taft
[1.1.1.1.1.1.4.7.4]
b. 1 Sep 1761 d. 26 Nov 1816
9
Zadock Taft
[1.1.1.1.1.1.4.7.5]
b. 15 Aug 1763 d. 15 Nov 1843
9
Willis Taft
[1.1.1.1.1.1.4.7.6]
b. 13 Aug 1765 d. 6 Dec 1841
8
Margaret Taft
[1.1.1.1.1.1.4.8]
b. 9 Feb 1729
6
Matthew Taft
[1.1.1.1.1.2]
b. 1642
5
Margaret Taft
[1.1.1.1.2]
b. 18 Mar 1617 d. 25 Aug 1684
5
Elizabeth Taft
[1.1.1.1.3]
b. 5 May 1620 d. 9 May 1627
5
Nicholas Taft
[1.1.1.1.4]
c. 21 Nov 1623 d. Aug 1624
5
Thomas Taft
[1.1.1.1.5]
b. 12 Oct 1625 d. 1 Dec 1625