Home Page
|
What's New
|
Photos
|
Histories
|
Headstones
|
Reports
|
Surnames
Search
First Name:
Last Name:
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Suomalainen
Svenska
Nicholas Taft
1514 -
Submit Photo / Document
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Submit Photo / Doc
Worksheet
Family
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Nicholas Taft
[1]
b. 1514
Margaret Milner
b. 1514 d. 18 Mar 1617
2
Robert Taft
[1.1]
b. 1534 d. 9 Sep 1590
Margaret Fane
b. 1538 d. 1584
3
Nicholas Taft
[1.1.1]
b. 1584 d. 1 Jan 1629
Margaret Milner
b. 13 Oct 1587 d. 18 Mar 1627
4
Richard Robert Taft
[1.1.1.1]
b. 1614 d. 1700
Margaret Faun
b. 1620 d. 1685
5
Robert Taft
[1.1.1.1.1]
b. 1640 d. 8 Feb 1725
Sarah Simpson
b. 1640 d. 8 Nov 1726
6
Thomas Taft
[1.1.1.1.1.1]
b. 1671 d. 1755
Deborah Chenery
b. 9 Jun 1671 d. 9 Aug 1747
7
Joseph Taft
[1.1.1.1.1.1.1]
b. 26 May 1693 d. 20 Oct 1761
Hannah Cook
b. 29 Sep 1695 d. 2 Aug 1771
8
Aaron Taft
[1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 26 Aug 1721 d. 4 Nov 1722
8
Joseph Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2]
b. 15 Jan 1724 d. 1 Feb 1803
Elisabeth Cummings
d. 27 Aug 1770
9
Thomas Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.1]
b. 19 Aug 1754
9
Elisabeth Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.2]
b. 1 Jul 1756 d. 4 Sep 1797
9
Nathan Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.3]
b. 3 Jun 1758
9
Phebe Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.4]
b. 26 Nov 1760
+
Aaron Balkam
b. 1760 d. 1842
9
Eunice Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.5]
b. 11 Feb 1761 d. 1833
9
Hannah Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.6]
b. 1 Nov 1763 d. 3 Jul 1832
Eastman Taft
b. 16 Jun 1763 d. 29 Apr 1829
10
Chloe Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.1]
b. 7 Jul 1785 d. 25 Apr 1826
John Perry Benson
b. 22 Jul 1781 d. 21 Jan 1842
11
Charlotte Taft Benson
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.1]
b. 30 Sep 1807 d. 16 Jul 1878
Moses Dyer
b. 1803 d. Aft 1841
12
Merril B Dyer
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.1.1]
b. 2 Apr 1844 d. 2 Apr 1859
12
George Franklin Dyer
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.1.2]
b. 22 Jan 1846 d. 27 Feb 1917 [
=>
]
12
Chloe Allice Dyer
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.1.3]
b. 5 May 1848 d. 1932 [
=>
]
12
Angelne A Dyer
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.1.4]
b. 6 Sep 1852 [
=>
]
11
Ezra Taft Benson
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.2]
b. 22 Feb 1811 d. 3 Sep 1869
Pamelia Andrus
b. 21 Oct 1809 d. 14 Sep 1877
12
Charles Agustus Benson
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.2.1]
b. 26 Sep 1832 d. 14 Oct 1833
12
Chloe Jane Benson
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.2.2]
b. 1835 d. 1835
12
Charles Augustus Benson
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.2.3]
b. 9 Jul 1837 d. 18 Feb 1873
12
Jonathan Parsons Benson
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.2.4]
b. Mar 1841 d. Mar 1841
12
Adin Parsons Benson
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.2.5]
b. Mar 1841 d. Mar 1841
12
Pamelia Emma Benson
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.2.6]
b. 28 Feb 1842 d. 10 Feb 1892
12
Harvey Andrus Benson
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.2.7]
b. 26 Sep 1844 d. 26 Sep 1844
12
Isabella Benson
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.2.8]
b. 9 Mar 1846 d. 10 Feb 1922
12
Charlotte Taft Benson
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.2.9]
b. 4 Jul 1850 d. 30 Nov 1918 [
=>
]
Adeline Brooks Andrus
b. 18 Mar 1813 d. 20 Apr 1898
12
George Taft Benson
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.2.10]
b. 1 May 1846 d. 16 May 1919 [
=>
]
12
Florence Adeline Benson
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.2.11]
b. 17 Sep 1851 d. 25 Dec 1852
12
Nellie Benson
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.2.12]
b. 30 Nov 1851 d. 24 Jan 1885
12
Frank Andrus Benson
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.2.13]
b. 16 Oct 1853 d. 5 May 1937 [
=>
]
12
Samuel Benson
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.2.14]
b. 1853
Eliza Ann Perry
b. 30 Mar 1828 d. 30 Apr 1913
12
Alice Eliza Benson
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.2.15]
b. 11 Aug 1848 d. 3 Jun 1923
12
John Perry Benson
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.2.16]
b. 24 Sep 1849 d. 4 Jan 1921
12
Malina Adelaide Benson
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.2.17]
b. 21 Sep 1851 d. 31 Jul 1918
12
Orrin William Benson
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.2.18]
b. 4 Oct 1853 d. 17 May 1917
12
Carrie Stella Benson
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.2.19]
b. 22 May 1860 d. 15 Mar 1928
12
Abbie Della Benson
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.2.20]
b. 16 Oct 1862 d. 22 Oct 1925
12
Grace Ann Benson
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.2.21]
b. 31 Jan 1867 d. 15 Dec 1924
Elizabeth Gollaher
b. 30 Dec 1831 d. 4 May 1904
12
Fredrick Gollaher Benson
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.2.22]
b. 17 Jan 1855 d. 6 Jan 1915
12
Brigham Young Benson
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.2.23]
b. 17 Dec 1858 d. 11 Jul 1938
12
Luella Gollaher Benson
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.2.24]
b. 12 Nov 1860 d. 22 Jul 1881
12
William C Benson
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.2.25]
b. 11 Nov 1862 d. Sep 1937
12
Hyrum Smith Benson
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.2.26]
b. 3 May 1864 d. 4 May 1935
12
Edith Benson
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.2.27]
b. 22 Apr 1867 d. 11 Feb 1925
12
Lizzie Gollaher Benson
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.2.28]
b. 9 Jul 1869 d. 30 Jul 1946
Olive Mary Knight
b. 24 Jan 1830 d. 27 Mar 1905
12
Louisa Benson
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.2.29]
b. 29 Jun 1852 d. 29 Nov 1878
12
Heber Benson
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.2.30]
b. Abt 1860 d. Bef 1868
12
Moroni Benson
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.2.31]
b. 5 Nov 1861 d. 8 Jan 1934
12
Lorenzo Taft Benson
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.2.32]
b. 3 Aug 1863 d. 6 Nov 1950
12
Joseph Benson
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.2.33]
b. 13 Jul 1865 d. 5 Jun 1941
12
Ida May Benson
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.2.34]
b. 16 Apr 1867 d. 30 Jun 1929
12
Don Carlos Benson
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.2.35]
b. 29 Sep 1869 d. 19 Jan 1935
Mary Marie Larsen
b. 19 Dec 1843 d. 21 Feb 1926
12
Walter Taft Benson
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.2.36]
b. 17 Jun 1867 d. 6 Jun 1957
12
Henry Taft Benson
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.2.37]
b. 19 Mar 1869 d. 24 Feb 1947
+
Desdemona Wadsworth Fullmer
b. 6 Oct 1809 d. 9 Feb 1886
+
Lucinda Burton
b. 22 Oct 1825 d. 1 Oct 1863
11
George Taft Benson
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.3]
b. Abt 1813
Prudence Maria Gifford
b. Abt 1815
12
Walter Everet Benson
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.3.1]
b. 13 Sep 1857 d. 29 Apr 1907 [
=>
]
11
Hannah Benson
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.4]
b. 18 Sep 1816
Henry Dodge
b. 15 Dec 1812 d. 22 Jun 1883
12
John M Dodge
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.4.1]
b. 1838 d. 14 Feb 1898
12
Abbie R Dodge
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.4.2]
b. 1850 d. 27 Sep 1916 [
=>
]
11
Abbie Ann Benson
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.5]
b. Abt 1809 d. 21 Sep 1883
Calvin Rawson
b. 13 May 1797 d. 21 Jan 1868
12
Son Rawson
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.5.1]
b. Abt 1828 d. Abt 1838
11
John M Benson
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.1.6]
b. 1819 d. 12 Aug 1829
10
Ezra Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.6.2]
b. 6 Mar 1793 d. 19 Feb 1808
9
Leonard Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.7]
b. 29 Mar 1767 d. 6 Feb 1846
Asenah Thayer
b. 7 Dec 1769 d. 22 Jul 1824
10
Willard Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.7.1]
b. 25 Aug 1791 d. 25 Feb 1832
Marietta Boyd
b. 1803
11
George Willard Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.7.1.1]
b. 27 Aug 1816 d. 1870
11
Susan Smith Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.7.1.2]
b. 3 Jun 1818 d. 1875
+
Abner Aldrich
b. 29 Aug 1806
11
Asenath Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.7.1.3]
b. 21 Sep 1820 d. 18 May 1843
Richard C Pollock
b. 12 Feb 1819 d. 21 Dec 1843
12
Emma Adelaid Pollock
[1.1.1.1.1.1.1.2.7.1.3.1]
b. 1 Jun 1842
11
Joseph Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.7.1.4]
b. 1828 d. 7 Oct 1831
11
Son Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.7.1.5]
b. 1831 d. 23 Jun 1832
10
Joseph Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.7.2]
b. 14 Oct 1793 d. 20 Dec 1869
Sophia Boyd
b. Abt 1800
11
Elmira D R Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.7.2.1]
b. 1821
George Washburn Rhodes
b. 7 Oct 1820
12
Son Rhodes
[1.1.1.1.1.1.1.2.7.2.1.1]
b. 23 Jul 1844
12
Margaret E Rhodes
[1.1.1.1.1.1.1.2.7.2.1.2]
b. 12 Mar 1846
12
Georgiaette A Rhodes
[1.1.1.1.1.1.1.2.7.2.1.3]
b. 11 Apr 1848
12
George Washington Rhodes
[1.1.1.1.1.1.1.2.7.2.1.4]
b. 1850
12
William Rhodes
[1.1.1.1.1.1.1.2.7.2.1.5]
b. 28 Nov 1851
12
Mary Josephine Rhodes
[1.1.1.1.1.1.1.2.7.2.1.6]
b. 4 Nov 1854
11
William A Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.7.2.2]
b. Abt 1836
+
Mary L Lane
b. Abt 1851
10
Duty Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.7.3]
b. 30 Jun 1796 d. 22 Oct 1830
Judy Rounds
b. Abt 1797
11
David Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.7.3.1]
b. 13 Sep 1825 d. 26 Mar 1826
11
James Madison Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.7.3.2]
b. 27 Dec 1827 d. 21 Nov 1892
9
Cummings Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.8]
b. 27 Aug 1770 d. 22 Jun 1841
Marcy Green
b. 1 Jan 1760 d. 8 Jun 1815
10
Ezra Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.8.1]
b. 13 May 1797 d. 16 Nov 1878
Mercy G White
b. 1796 d. 14 Mar 1822
11
Austin Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.8.1.1]
b. 1 Mar 1822 d. 4 Sep 1844
Susanna Keith
b. 3 Jan 1801
11
Laura Ann M Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.8.1.2]
b. 26 Jun 1824 d. 26 May 1855
Oliver Taft
b. 6 Nov 1771 d. 20 Feb 1853
12
Laura Ann Maria Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.8.1.2.1]
b. 7 Jul 1844
12
Son Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.8.1.2.2]
b. 7 Jul 1844 d. 21 Jul 1844
12
Joseph K Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.8.1.2.3]
b. 25 Sep 1846 d. Jul 1868
12
Chloe Jane Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.8.1.2.4]
b. 25 Nov 1849
11
Lucinda M Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.8.1.3]
b. 15 Mar 1826 d. 5 Mar 1906
Charles White
b. 1825 d. 25 Mar 1899
12
Alice Maria White
[1.1.1.1.1.1.1.2.8.1.3.1]
b. 7 May 1865 d. 10 Dec 1892 [
=>
]
12
Walter Arnold White
[1.1.1.1.1.1.1.2.8.1.3.2]
b. 9 May 1869 [
=>
]
11
Artemas K Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.8.1.4]
b. 24 May 1828 d. 27 Dec 1878
Jane
b. 1827
12
Olive A Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.8.1.4.1]
b. Abt 1850
12
Albert Eugene Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.8.1.4.2]
b. 13 Aug 1852
12
Susan Ellen Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.8.1.4.3]
b. Abt 1859 [
=>
]
12
John Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.8.1.4.4]
b. 3 Jun 1864
12
Jane Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.8.1.4.5]
b. 3 Jun 1864
11
Uranah Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.8.1.5]
b. 25 Jan 1831
11
Daines C Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.8.1.6]
b. 1835
Olive Cleveland Smith
b. 16 Oct 1828 d. 15 Mar 1910
12
George Edward Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.8.1.6.1]
b. 7 Feb 1860 d. 10 Oct 1860
12
Celinda Grace Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.8.1.6.2]
b. 19 Aug 1861
12
Albert Smith Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.8.1.6.3]
b. 7 Feb 1867
11
Susan A Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.8.1.7]
b. 1838
11
Hannah Jane Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.8.1.8]
b. 17 Nov 1839 d. 7 Jan 1848
10
Benjamin Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.8.2]
b. 10 Aug 1798 d. 29 May 1799
10
Benjamin Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.8.3]
b. 6 May 1800 d. 17 Oct 1828
Martha Bethsheba White
b. 1803
11
Benjamin Lorin Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.8.3.1]
b. 25 Jun 1823
+
Paulina Wheelock
b. 27 Oct 1827
11
Russell White Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.8.3.2]
b. 23 Jan 1826 d. 4 Dec 1868
10
Hannah G Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.8.4]
b. 18 May 1802 d. 8 Jan 1843
Newell Taft
b. 28 Jul 1804 d. 4 Nov 1873
11
Albert Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.8.4.1]
b. 28 Aug 1823 d. Aft 1874
Sally L Bartlett
b. 14 Oct 1827 d. 1 Sep 1874
12
Charles B Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.8.4.1.1]
b. Feb 1854 d. 23 Sep 1854
12
Hannah L Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.8.4.1.2]
b. 5 Feb 1856
11
Marcy Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.8.4.2]
b. Mar 1829 d. 12 Apr 1830
11
Charles M Taft
[1.1.1.1.1.1.1.2.8.4.3]
b. Jan 1843 d. 7 Dec 1843
8
Hannah Taft
[1.1.1.1.1.1.1.3]
b. 16 Nov 1725 d. 4 Nov 1822
Peter Keith
b. 23 Apr 1727 d. 1790
9
Joseph Keith
[1.1.1.1.1.1.1.3.1]
b. 20 Jul 1749
9
Debora Keith
[1.1.1.1.1.1.1.3.2]
b. 2 May 1751
9
Hannah Keith
[1.1.1.1.1.1.1.3.3]
b. 17 Jul 1753 d. 2 Apr 1842
Joseph Taft
b. 6 Jul 1751 d. 2 Jul 1828
10
Oliver Taft
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.1]
b. 6 Nov 1771 d. 20 Feb 1853
Chloe
b. 1782 d. 24 Nov 1841
11
Olive Taft
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.1]
b. 1 Mar 1806 d. 27 Jan 1867
11
Amariah Taft
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.2]
b. 19 Sep 1807 d. 28 Aug 1873
Mary Richards
b. Abt 1819 d. 22 Apr 1875
12
Ophelia Adams Taft
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.2.1]
b. 23 Jan 1841 [
=>
]
12
Mary Elizabeth Taft
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.2.2]
b. 23 May 1843 d. 8 Apr 1845
12
Francis Amariel Taft
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.2.3]
b. 18 Sep 1847 d. 28 Jul 1848
11
Oliver Taft
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.3]
b. 16 Jun 1812 d. 25 Mar 1876
Sarah Richardson
b. 1821
12
Horace H Taft
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.3.1]
b. 1846 d. 11 May 1863
12
Jennis Isadora Taft
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.3.2]
b. 12 Apr 1857 d. 21 Aug 1863
11
Maryan Taft
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.4]
b. 9 Jul 1814
Hosea Aldrich
b. 14 Mar 1803
12
Chloe M Aldrich
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.4.1]
b. 17 Jan 1838
12
Watee E Aldrich
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.4.2]
b. 1 Sep 1840
12
Sylvia Ann Aldrich
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.4.3]
b. 20 Jul 1844
11
George Washington Taft
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.5]
b. 13 May 1823
Laura Ann M Taft
b. 26 Jun 1824 d. 26 May 1855
11
Laura Ann Maria Taft
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.6]
b. 7 Jul 1844
11
Son Taft
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.7]
b. 7 Jul 1844 d. 21 Jul 1844
11
Joseph K Taft
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.8]
b. 25 Sep 1846 d. Jul 1868
11
Chloe Jane Taft
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.9]
b. 25 Nov 1849
10
Huldah Taft
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.2]
b. 17 Feb 1775 d. Bef 21 May 1780
10
Huldah Taft
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.3]
b. 21 May 1780 d. 11 Oct 1811
Parker Tyler
b. 14 Nov 1790 d. 28 Jun 1853
11
Huldah Tyler
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.3.1]
b. 4 Oct 1811
Matthew Borland
b. Abt 1800
12
Huldah J Borland
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.3.1.1]
b. 28 Sep 1831 d. 10 Nov 1907 [
=>
]
12
Margaret Borland
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.3.1.2]
b. 13 Apr 1836 d. 21 Oct 1882 [
=>
]
12
Samuel Borland
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.3.1.3]
b. Abt 1841
12
John P Borland
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.3.1.4]
b. Abt 1849
11
Hannah Tyler
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.3.2]
b. 4 Oct 1811 d. 18 Oct 1811
11
Martha Almira Tyler
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.3.3]
b. 28 Sep 1830 d. 16 Oct 1909
William S Jones
b. 26 Sep 1827 d. 26 Sep 1907
12
Anna Almira Jones
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.3.3.1]
b. 16 Jun 1850 d. 2 May 1922 [
=>
]
12
Wilber Jones
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.3.3.2]
b. 1852
12
Albert J Jones
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.3.3.3]
b. 10 Jun 1857 d. 17 Jun 1937 [
=>
]
12
Eva Jones
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.3.3.4]
b. 29 May 1861 d. 13 Aug 1924
12
Wilbur Sherman Jones
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.3.3.5]
b. 17 Oct 1865 d. 1942
10
Hannah Taft
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.4]
b. 29 Sep 1783
10
Peter Taft
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.5]
b. 24 Apr 1786
9
Mary Keith
[1.1.1.1.1.1.1.3.4]
b. 17 Sep 1755
9
Esther Keith
[1.1.1.1.1.1.1.3.5]
b. 23 Jan 1758 d. 4 Oct 1761
9
Peter Keith
[1.1.1.1.1.1.1.3.6]
b. 3 May 1760
+
Esther Alton
b. 23 Jun 1756
9
Barak Keith
[1.1.1.1.1.1.1.3.7]
b. 25 Aug 1762 d. 26 Mar 1833
9
Marshal Keith
[1.1.1.1.1.1.1.3.8]
b. 4 May 1765 d. 1817
9
Stephen Keith
[1.1.1.1.1.1.1.3.9]
b. 24 Aug 1768
8
Noah Taft
[1.1.1.1.1.1.1.4]
b. 1726 d. 2 Sep 1814
Margaret Keith
b. 1733 d. 1803
9
Deborah Taft
[1.1.1.1.1.1.1.4.1]
b. 30 Sep 1753
+
Samuel Penniman
b. 1 Dec 1748
9
Timothy Taft
[1.1.1.1.1.1.1.4.2]
b. 16 Feb 1755 d. 16 Nov 1827
Abigail Wright
b. 29 Nov 1754 d. 22 Nov 1840
10
Mary Taft
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.1]
b. 20 Jan 1780 d. 15 Nov 1863
Peter Foster
b. 11 Feb 1779 d. 15 Aug 1829
11
Taft Foster
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.1.1]
b. 7 Mar 1801 d. 16 Feb 1852
11
Loring Foster
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.1.2]
b. 19 Feb 1803
11
Luther Foster
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.1.3]
b. 6 Jan 1805 d. 9 Oct 1857
11
Eliza Foster
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.1.4]
b. 21 Dec 1806
11
Adeline Foster
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.1.5]
b. 10 Dec 1808 d. 8 May 1884
11
Emily Foster
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.1.6]
b. 13 Jan 1811 d. 1884
11
Nancy Foster
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.1.7]
b. 16 Jun 1813
+
John W Wheeler
b. 1811
11
Albert Foster
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.1.8]
b. 8 Apr 1817 d. 23 Jun 1890
11
Mary E Foster
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.1.9]
b. 25 Sep 1822
11
Demarcus Foster
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.1.10]
b. 3 Apr 1825 d. 19 Oct 1876
Lydia B Whittemore
b. 26 Feb 1830 d. 4 Nov 1911
12
Elroy Demarcus Foster
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.1.10.1]
b. 14 Nov 1856 d. 1915
12
Rosae Belle Foster
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.1.10.2]
b. 3 Dec 1858 d. 1915
12
Elmer Ellsworth Foster
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.1.10.3]
b. 29 Apr 1861 d. 1917
12
Frederick Woodbury Foster
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.1.10.4]
b. 1 Aug 1863 d. 18 Apr 1864
12
Wallace B Foster
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.1.10.5]
b. 26 Nov 1864 d. 21 Jul 1948 [
=>
]
10
Sullivan Taft
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.2]
b. 4 Sep 1781 d. 20 Mar 1865
Sally Flagg
b. 5 Mar 1783 d. 23 Aug 1870
11
Abigail Wright Taft
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.2.1]
b. 25 Jul 1805 d. 22 Nov 1840
Philander A Adams
b. Abt 1801 d. 1 Apr 1864
12
Son Adams
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.2.1.1]
b. Aug 1839 d. Aug 1839
12
Robert Webster Adams
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.2.1.2]
b. 1843
11
Timothy Sullivan Taft
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.2.2]
b. 21 Dec 1806
+
Lucretia Smith
b. 12 Nov 1806
11
Mary Flagg Taft
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.2.3]
b. 25 Oct 1808 d. 8 Aug 1900
Lemuel Martindale Bolton
b. 21 Feb 1811 d. 17 Sep 1857
12
Olive Maria Bolton
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.2.3.1]
b. 1838 d. 10 Mar 1840
12
William Henry Bolton
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.2.3.2]
b. 3 Aug 1840 d. 8 Aug 1912 [
=>
]
12
Son Bolton
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.2.3.3]
b. 1842 d. 3 Apr 1843
12
Lemuel M Bolton
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.2.3.4]
b. 3 May 1844 d. 6 Apr 1865
12
George C Bolton
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.2.3.5]
b. 20 Sep 1846 d. 1924 [
=>
]
12
Samuel Bolton
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.2.3.6]
b. Sep 1851 d. 5 May 1859
11
Lucy Eliza Taft
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.2.4]
b. 8 Dec 1810 d. 10 Jun 1893
William Gleason
b. 12 Sep 1805 d. 25 Sep 1861
12
William Sullivan Gleason
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.2.4.1]
b. 23 Sep 1830 [
=>
]
12
Androniran Gleason
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.2.4.2]
b. 2 Dec 1831 d. 28 Jul 1866
12
George B Gleason
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.2.4.3]
b. 7 Sep 1833 d. 23 Sep 1833
12
Lucy M Gleason
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.2.4.4]
b. 13 Aug 1834
12
Sarah Celicia Gleason
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.2.4.5]
b. 13 Aug 1836 d. 26 Feb 1861
12
John W Gleason
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.2.4.6]
b. 21 Aug 1838
12
James Homer Gleason
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.2.4.7]
b. 19 Mar 1840 d. 22 Apr 1861
12
Charles F Gleason
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.2.4.8]
b. 7 Dec 1841
12
Thomas Spenser Gleason
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.2.4.9]
b. 5 Jun 1843 d. 31 May 1862
12
Edward Homer Gleason
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.2.4.10]
b. 29 Apr 1845 d. 17 Jan 1862
12
Julia A Gleason
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.2.4.11]
b. 29 Aug 1847
11
Sarah Maria Taft
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.2.5]
b. 25 Feb 1813 d. 23 Jul 1876
Orville Short Brown
b. 23 Dec 1814 d. 2 Jul 1845
12
George Russell Brown
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.2.5.1]
b. 25 Oct 1837
12
Son Brown
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.2.5.2]
b. 29 Mar 1839 d. 30 Mar 1839
12
Mary M Brown
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.2.5.3]
b. 2 Aug 1840
12
Son Brown
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.2.5.4]
b. 14 Nov 1844
11
Andrew Jackson Taft
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.2.6]
b. 17 Apr 1815 d. 16 Feb 1817
11
Andrew Jackson Taft
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.2.7]
b. 16 Feb 1817 d. 1909
Eliza Lawrence
b. 11 Apr 1810 d. 12 Aug 1880
12
James Edward Taft
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.2.7.1]
b. 25 Feb 1849 [
=>
]
11
Adoniram Judson Taft
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.2.8]
b. 15 Dec 1819
10
Adolphus Taft
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.3]
b. 10 Jul 1784 d. 8 Feb 1857
Polly Johnson
b. 26 Nov 1783 d. 24 Nov 1864
11
Sarah Johnson Taft
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.3.1]
b. 29 Nov 1809
11
Mary Adaline Taft
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.3.2]
b. 27 Jun 1812 d. 25 Feb 1895
Albert Adams Partridge
b. 2 May 1814 d. 18 Apr 1899
12
Albert Harding Partridge
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.3.2.1]
b. 9 Aug 1840 d. Mar 1884
12
Adaline E Partridge
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.3.2.2]
b. 9 May 1844 d. Jan 1884
12
Ellen M Partridge
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.3.2.3]
b. 15 May 1846
12
Elbridge Gerry Partridge
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.3.2.4]
b. 12 May 1848 [
=>
]
12
Abigail R Partridge
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.3.2.5]
b. 14 Mar 1850 d. 6 Apr 1895 [
=>
]
12
Emma F Partridge
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.3.2.6]
b. 3 Jul 1852
12
Maria A Partridge
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.3.2.7]
b. 25 Sep 1854 [
=>
]
11
William Harrison Taft
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.3.3]
b. 8 Nov 1814 d. 27 Jun 1853
11
Betsy Eaton Taft
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.3.4]
b. 14 Jan 1817
11
Rebecca Eaton Taft
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.3.5]
b. 14 Mar 1819
11
Sylvia Holbrook Taft
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.3.6]
b. 28 May 1821
11
George Washington Taft
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.3.7]
b. 29 Aug 1823
10
David Taft
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.4]
b. 1 Jan 1786
+
Azubah Elder
b. 1790
10
Joseph Taft
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.5]
b. 26 Jun 1791 d. 15 May 1865
9
Emmeline Taft
[1.1.1.1.1.1.1.4.3]
b. Abt 1757
9
Noah Taft
[1.1.1.1.1.1.1.4.4]
b. 14 Jan 1758 d. 25 Feb 1828
Charlotte Arnold
b. 4 Sep 1771 d. 5 Feb 1848
10
Almira Taft
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.1]
b. 9 Jun 1800 d. 1873
Collins Thayer
b. 7 Apr 1790 d. 19 Sep 1855
11
Adeline Thayer
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.1.1]
b. 1817
11
Virginia Thayer
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.1.2]
b. 1821
11
Elizabeth Thayer
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.1.3]
b. 1823
11
Collins Thayer
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.1.4]
b. 1825
11
Susan Thayer
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.1.5]
b. 27 Dec 1826
Charles Henry Guild
b. 25 Mar 1823
12
Virginia Melora Guild
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.1.5.1]
b. 22 Dec 1846 d. 17 Jul 1929
12
Charles Samuel Guild
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.1.5.2]
b. 18 Oct 1848
12
Willard Temple Guild
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.1.5.3]
b. 12 Feb 1855 d. 29 Jun 1855
11
Olive A Thayer
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.1.6]
b. Abt 1827
11
Mary Thayer
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.1.7]
b. 1828
Almarine A Gwaltney
b. 1824
12
James A Gwaltney
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.1.7.1]
b. 1851
12
Ella Gwaltney
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.1.7.2]
b. 9 Feb 1856 d. 1920
12
Luther Gwaltney
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.1.7.3]
b. Mar 1858 [
=>
]
12
Frances Gwaltney
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.1.7.4]
b. 1860
12
Georgia Gwaltney
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.1.7.5]
b. Feb 1863 d. 1940
12
Susie Gwaltney
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.1.7.6]
b. 1864
11
Almira Thayer
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.1.8]
b. 1831 d. 1895
10
Arnold Taft
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.2]
b. 3 Feb 1793 d. 4 Feb 1865
Nancy Thayer
b. 1786 d. 1852
11
Mary Thayer
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.2.1]
b. 20 Sep 1820 d. 10 Oct 1888
Nehemiah White Lee
b. 16 Mar 1819 d. 20 Apr 1890
12
Charles Arnold Lee
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.2.1.1]
b. 14 Dec 1845 d. 16 May 1900 [
=>
]
12
Walter Orman Lee
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.2.1.2]
b. 6 Feb 1848 d. 16 Apr 1881 [
=>
]
12
Harrit Taft Lee
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.2.1.3]
b. 4 May 1852 d. 8 Apr 1888
12
Joseph Newton Lee
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.2.1.4]
b. 25 Feb 1864 d. Sep 1943
12
Mary Anna Elizabeth Lee
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.2.1.5]
b. 30 Nov 1859 d. 29 Jun 1945 [
=>
]
10
Noah Taft
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.3]
b. 1795 d. 31 Oct 1869
10
Charlotte A Taft
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.4]
b. 1796
10
Daniel O Taft
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.5]
b. 1797 d. 11 May 1871
10
Susanna Taft
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.6]
b. 1798 d. 1875
10
Mary A Taft
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.7]
b. 1802 d. 23 May 1804
10
Olive Taft
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.8]
b. 1804
9
Keith Taft
[1.1.1.1.1.1.1.4.5]
b. 1761 d. 10 Sep 1825
9
Chloa Taft
[1.1.1.1.1.1.1.4.6]
b. 25 Nov 1763 d. 4 May 1783
Eastman Taft
b. 16 Jun 1763 d. 29 Apr 1829
10
Eastman Taft
[1.1.1.1.1.1.1.4.6.1]
b. 2 May 1783 d. 8 Aug 1857
9
Micajah Taft
[1.1.1.1.1.1.1.4.7]
b. 8 Mar 1766 d. 9 Sep 1849
9
Charlotte Taft
[1.1.1.1.1.1.1.4.8]
b. 10 Jun 1768
9
David Taft
[1.1.1.1.1.1.1.4.9]
b. 1770 d. 5 May 1832
9
Gersham Taft
[1.1.1.1.1.1.1.4.10]
b. 1772
9
Joseph Taft
[1.1.1.1.1.1.1.4.11]
b. 1772 d. 23 Aug 1830
9
Charlotte Taft
[1.1.1.1.1.1.1.4.12]
b. 1774 d. 21 Jan 1777
8
Ezra Taft
[1.1.1.1.1.1.1.5]
b. 15 Apr 1731 d. 1761
8
Experience Taft
[1.1.1.1.1.1.1.6]
b. 7 Apr 1733 d. 15 Mar 1817
Elisha Taft
b. 3 May 1728 d. 3 Mar 1791
9
Hannah Taft
[1.1.1.1.1.1.1.6.1]
b. 16 Mar 1758
9
Elisha Taft
[1.1.1.1.1.1.1.6.2]
b. 4 Mar 1761 d. 16 Jan 1820
Mary Sadler
b. 15 Aug 1768 d. 1800
10
Hiram Taft
[1.1.1.1.1.1.1.6.2.1]
b. 2 Apr 1789 d. 15 Nov 1794
10
Elisha Taft
[1.1.1.1.1.1.1.6.2.2]
b. 23 Jul 1791 d. 26 Feb 1858
10
Ormon Taft
[1.1.1.1.1.1.1.6.2.3]
b. 11 Nov 1793 d. 23 Jan 1794
10
Mary Taft
[1.1.1.1.1.1.1.6.2.4]
b. 23 May 1795 d. 23 Feb 1875
9
Sarah Taft
[1.1.1.1.1.1.1.6.3]
b. 21 Mar 1763 d. 11 Oct 1835
Ezra Wood, Jr
b. 12 Mar 1759 d. 10 May 1837
10
Ezra Wood
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.1]
b. 25 Oct 1781
10
Experience Wood
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.2]
b. 16 Mar 1783 d. 14 Oct 1818
10
Sarah Wood
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.3]
b. 7 Aug 1784
10
Elisha Wood
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.4]
b. 24 Apr 1786 d. 19 Oct 1797
10
Jonathan Wood
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.5]
b. 8 Oct 1787 d. 26 Feb 1846
10
Anna Wood
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.6]
b. 31 Aug 1789 d. 20 Mar 1832
10
Chapin Wood
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.7]
b. 2 Apr 1792
10
Lucy Wood
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.8]
b. 11 Nov 1794 d. 10 Dec 1826
10
Silva Wood
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.9]
b. 29 Apr 1796
10
Silva Wood
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.10]
b. 29 Apr 1796
10
Phila Wood
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.11]
b. 5 Jul 1798
10
Elisha Wood
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.12]
b. 7 Nov 1800
10
Simeon Wood
[1.1.1.1.1.1.1.6.3.13]
b. 5 Jan 1805
9
Israel Taft
[1.1.1.1.1.1.1.6.4]
b. 12 Feb 1766
9
Joseph Taft
[1.1.1.1.1.1.1.6.5]
b. 15 Sep 1768 d. Aft 29 Sep 1815
Sarah Farrar
b. 14 Sep 1764 d. 5 Aug 1810
10
Experience
[1.1.1.1.1.1.1.6.5.1]
b. 5 Feb 1792
10
Amiel F Taft
[1.1.1.1.1.1.1.6.5.2]
b. 1 Oct 1794 d. 29 Nov 1869
10
Roxalana Taft
[1.1.1.1.1.1.1.6.5.3]
b. 22 Jan 1798
10
Sofrona Taft
[1.1.1.1.1.1.1.6.5.4]
b. 17 Jun 1800
10
Esquire Taft
[1.1.1.1.1.1.1.6.5.5]
b. 28 Apr 1803 d. 11 Mar 1865
10
Deborah R Taft
[1.1.1.1.1.1.1.6.5.6]
b. 6 Jan 1806
+
Marcy Stockwell
b. Abt 1794
8
Deborah Taft
[1.1.1.1.1.1.1.7]
b. 11 May 1735 d. 10 Dec 1738
8
Deborah Taft
[1.1.1.1.1.1.1.8]
b. 12 Mar 1744 d. 10 Dec 1778
7
Sarah Taft
[1.1.1.1.1.1.2]
b. 29 May 1695 d. 1719
Thomas Tenney
b. 28 May 1681
8
Elizabeth Tenney
[1.1.1.1.1.1.2.1]
b. Abt 1709 d. 9 Feb 1709
8
Elizabeth Tenney
[1.1.1.1.1.1.2.2]
b. 15 Jan 1713 d. Abt 1736
8
Phebe Tenney
[1.1.1.1.1.1.2.3]
b. 5 Jan 1716 d. 19 Sep 1756
7
Eleazer Taft
[1.1.1.1.1.1.3]
b. 5 Apr 1697 d. 29 Aug 1759
Rachel Thayer
b. 5 Mar 1700 d. 1759
8
Aaron Taft
[1.1.1.1.1.1.3.1]
b. 20 Jul 1722 d. 24 Apr 1764
8
Moses Taft
[1.1.1.1.1.1.3.2]
b. 20 Jul 1722 d. 12 Nov 1791
8
Sarah Taft
[1.1.1.1.1.1.3.3]
b. 2 Nov 1727
8
Joshua Taft
[1.1.1.1.1.1.3.4]
b. 14 Jan 1731 d. 1770
7
Hanna Taft
[1.1.1.1.1.1.4]
b. 17 Apr 1699
7
Rebecah Taft
[1.1.1.1.1.1.5]
b. 15 Mar 1701 d. 1748
7
Deborah Taft
[1.1.1.1.1.1.6]
b. 14 Nov 1702 d. 9 Aug 1747
Benjamin Wheelock
b. 10 Apr 1704 d. 1777
8
Benjamin Wheelock
[1.1.1.1.1.1.6.1]
b. 17 Aug 1729 d. 16 Apr 1776
8
Jesse Wheelock
[1.1.1.1.1.1.6.2]
b. 8 Sep 1731 d. Bef 4 Sep 1781
Phoebe White
b. 8 Oct 1737 d. Mar 1783
9
Phineas Wheelock
[1.1.1.1.1.1.6.2.1]
b. 28 Apr 1754 d. 21 Jun 1759
9
Enock Wheelock
[1.1.1.1.1.1.6.2.2]
b. 14 Oct 1755
9
Mary Wheelock
[1.1.1.1.1.1.6.2.3]
b. 23 May 1756 d. 5 Nov 1807
9
Nathan Wheelock
[1.1.1.1.1.1.6.2.4]
b. 20 Apr 1758
9
Nancy Wheelock
[1.1.1.1.1.1.6.2.5]
b. 14 Nov 1767 d. 9 Oct 1843
9
Abigail Wheelock
[1.1.1.1.1.1.6.2.6]
b. 16 Jan 1772
9
Baruch Wheelock
[1.1.1.1.1.1.6.2.7]
b. 4 Jan 1774 d. 28 Mar 1816
9
Submit Wheelock
[1.1.1.1.1.1.6.2.8]
b. 10 Jan 1782 d. 29 Jan 1823
8
Jonathan Wheelock
[1.1.1.1.1.1.6.3]
b. 8 Sep 1731 d. 1774
Ruth Daniels
b. 13 Jul 1738 d. 26 Sep 1798
9
Eleazer Wheelock
[1.1.1.1.1.1.6.3.1]
b. 15 Jul 1756 d. 1841
9
Dole Wheelock
[1.1.1.1.1.1.6.3.2]
b. 29 May 1758
9
Susannah Wheelock
[1.1.1.1.1.1.6.3.3]
b. 23 Feb 1760 d. 2 May 1776
9
Lyman Wheelock
[1.1.1.1.1.1.6.3.4]
b. 30 Nov 1761 d. 29 Mar 1848
9
Alphaeus Wheelock
[1.1.1.1.1.1.6.3.5]
b. 17 Dec 1763
9
Willard Wheelock
[1.1.1.1.1.1.6.3.6]
b. 19 Jun 1768 d. 29 Mar 1823
9
Deobrah Wheelock
[1.1.1.1.1.1.6.3.7]
b. 17 Dec 1765 d. 3 Aug 1846
Elkanah Benson
b. 21 Feb 1766 d. 8 Mar 1844
10
Samuel Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.1]
b. 21 May 1791
Mary Van Liew
b. 8 Jul 1797 d. 22 Apr 1859
11
William Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.1.1]
b. 18 Dec 1817
11
Emily Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.1.2]
b. 18 Dec 1817
+
George Van Heusen
b. 3 Jun 1816 d. 25 Mar 1872
11
Alzina Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.1.3]
b. 8 Nov 1819 d. 29 Mar 1867
+
Charles W Ingersoll
b. 1817
11
Augustus Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.1.4]
b. 10 Feb 1822
11
Phila Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.1.5]
b. 8 Mar 1824
William Jenkins
b. 1820 d. 14 May 1864
12
Walter Jenkins
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.1.5.1]
b. 1857 d. 14 May 1864
12
Emma Jenkins
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.1.5.2]
b. 1861
11
Nathan S Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.1.6]
b. 17 Sep 1826 d. 1869
Martha Mead
b. 1838
12
Cora Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.1.6.1]
b. Abt 1860
12
Florence E Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.1.6.2]
b. Feb 1862
12
Alice Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.1.6.3]
b. Abt 1864
12
Nellie Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.1.6.4]
b. Abt 1866
11
James Mapes Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.1.7]
b. 12 Jun 1828 d. 11 Oct 1907
Margaret Jane Williamson
b. 4 Dec 1834 d. 20 Feb 1905
12
Francis Coe Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.1.7.1]
b. 22 Feb 1860
12
James Clarence Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.1.7.2]
b. 24 May 1862 d. 12 Jul 1920 [
=>
]
11
Montgomery Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.1.8]
b. Abt 1833
11
Mary Ellen Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.1.9]
b. Abt 1839
+
Cyrus B Kinne
b. Jan 1835
10
Chloe Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.2]
b. 6 Jan 1793 d. 1882
Lewis Smith
b. Abt 1790
11
Mary Smith
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.2.1]
b. Abt 1813 d. 1913
+
Henry Gilman Darling
b. 16 Aug 1810 d. 17 Dec 1870
11
Sidney Smith
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.2.2]
b. 29 Jan 1815 d. 10 Sep 1900
Jennie Ann Calkins
b. 1835
12
Adelia Smith
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.2.2.1]
b. Apr 1866 [
=>
]
12
Anna Smith
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.2.2.2]
b. 1869
11
William Smith
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.2.3]
b. Abt 1817
11
Lewis Smith
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.2.4]
b. Abt 1820
11
Stephen Smith
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.2.5]
b. 19 Feb 1823 d. 26 Aug 1922
Lucy Colver
b. 13 Oct 1835 d. 12 Sep 1905
12
Florence Nightingale Smith
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.2.5.1]
b. 8 Nov 1861
12
Evangeline Smith
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.2.5.2]
b. Abt 1863 d. Abt 1868
12
Sidney Smith
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.2.5.3]
b. 23 Dec 1864
12
Caroline Smith
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.2.5.4]
b. 4 Aug 1866 d. 11 Mar 1868
12
Stephen Smith
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.2.5.5]
b. 27 Dec 1868 d. 8 Jan 1889
12
Evalyn C Smith
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.2.5.6]
b. 28 Dec 1868
12
Lucille Carroll Smith
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.2.5.7]
b. 30 Jan 1873
12
Dean Smith
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.2.5.8]
b. 28 Aug 1875
12
Anna Jaffray Smith
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.2.5.9]
b. 8 Jun 1878
11
Job Lewis Smith
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.2.6]
b. 15 Oct 1827 d. 9 Jun 1897
10
Adolphus Willard Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.3]
b. 17 Dec 1795 d. 18 May 1878
Hannah Vermilyea
b. 1796 d. 28 Jun 1886
11
Edward Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.3.1]
b. 1824
11
Bryon L Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.3.2]
b. 25 Dec 1825 d. 23 Oct 1912
Angelina Howard
b. 16 Jul 1836 d. 24 Nov 1922
12
Alice Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.3.2.1]
b. 15 Aug 1858 d. 19 May 1879
11
Lewis Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.3.3]
b. Abt 1827
11
Elizabeth Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.3.4]
b. Abt 1829
11
Ellen Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.3.5]
b. Abt 1831
11
John Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.3.6]
b. Abt 1833
11
Henry Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.3.7]
b. Abt 1835
11
Jane H Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.3.8]
b. Abt 1837
11
Frank Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.3.9]
b. Abt 1839
10
Eliza Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.4]
b. 9 Mar 1798 d. 13 Nov 1817
+
James Miller
b. Abt 1795
10
Leonard Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.5]
b. 7 Apr 1800 d. 7 Sep 1877
Ruth Ann Reynolds
b. 23 Jul 1805 d. 2 Feb 1853
11
Elisha Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.5.1]
b. 1829
Helen R Sherman
b. 1839
12
Hattie Isabel Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.5.1.1]
b. Abt 1860
12
Carrie A Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.5.1.2]
b. 4 Dec 1861 d. 1 Jul 1949 [
=>
]
12
Ida May Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.5.1.3]
d. Bef 1908
11
William R Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.5.2]
b. 1831 d. 26 Feb 1889
Lucy Ann Clark
b. 16 Dec 1836 d. 21 Feb 1903
12
Edith Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.5.2.1]
b. 1868
12
Melvin Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.5.2.2]
b. 1869 d. 1870
12
Eva L Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.5.2.3]
b. Mar 1875
11
John Thompson Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.5.3]
b. 25 May 1833 d. 2 Apr 1914
Louisa Clark
b. 18 Nov 1835 d. 23 Jan 1918
12
Jay Clark Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.5.3.1]
b. Aug 1856 d. 26 Aug 1937 [
=>
]
12
Leonard E Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.5.3.2]
b. Jun 1860 d. 3 Jan 1927
11
Emory J Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.5.4]
b. Jul 1836 d. 8 Mar 1926
Jane Ann Van Sickle
b. 20 Mar 1838
12
Ella L Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.5.4.1]
b. Abt 1863
12
Clarence Emery Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.5.4.2]
b. Jan 1870 [
=>
]
12
Alma Edna Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.5.4.3]
b. May 1880
+
Helen Rebecca Sherman
11
Finley E Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.5.5]
b. Abt 1841
Maria Higby
b. Abt 1843 d. Bef 1910
12
Marion Arthur Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.5.5.1]
b. 13 Nov 1868 d. Aft 28 Apr 1930 [
=>
]
12
Delbert Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.5.5.2]
b. Abt 1878
Hannah Sherman
11
Mary Isabelle Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.5.6]
b. 7 Jun 1853 d. 9 Dec 1935
Howard Spurgeon Green
b. 25 Aug 1850 d. 24 Jan 1912
12
Roy C Green
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.5.6.1]
b. 3 Nov 1879 d. Jul 1955 [
=>
]
12
Leonard Benson Green
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.5.6.2]
b. 10 Nov 1882 d. 24 Jul 1947
12
Helen Ione Green
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.5.6.3]
b. 23 Oct 1893
10
Phila Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.6]
b. 27 Jul 1802
Charles Warner
b. Abt 1800
11
Susan Warner
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.6.1]
b. 1828
11
Mary Warner
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.6.2]
b. 1830
11
Harriet Warner
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.6.3]
b. 1832
10
Calista Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.7]
b. 2 Jun 1804 d. 15 Sep 1882
Jacob Conklin
b. 19 Sep 1798 d. 1 Nov 1884
11
Sarah Conklin
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.7.1]
b. 1828
11
Edward Conklin
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.7.2]
b. Abt 1828
11
Sory Ann Conklin
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.7.3]
b. 1831 d. 7 Feb 1832
11
Benson Conklin
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.7.4]
b. May 1833
Tina Ann Roseboone
b. 1838
12
Ella Mary Abbott Conklin
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.7.4.1]
b. 16 May 1856
12
Frank B Conklin
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.7.4.2]
b. 1857
12
Gilbert Conklin
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.7.4.3]
b. 1859
12
Charles Conklin
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.7.4.4]
b. 1860 d. 6 Sep 1865
12
Lizzie Conklin
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.7.4.5]
b. 1862
12
Kittie E Conklin
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.7.4.6]
b. 1872
+
Della J Walsh
b. Feb 1838
11
John Conklin
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.7.5]
b. 1835 d. 25 Oct 1835
11
Maria Conklin
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.7.6]
b. 1837 d. 1850
11
Daughter Conklin
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.7.7]
b. 1840 d. 1840
11
Eugene Conklin
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.7.8]
b. 1841 d. 14 Apr 1912
Harriet Ann Van Etten
b. 1845 d. 2 Jun 1932
12
Nellie V Conklin
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.7.8.1]
b. 1872 d. 16 Sep 1893
12
Mary F Conklin
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.7.8.2]
b. 1881 d. 25 Aug 1960
11
Daughter Conklin
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.7.9]
b. 1843 d. 3 Mar 1843
11
Lewis Smith Conklin
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.7.10]
b. Nov 1845 d. 28 Feb 1905
Persis Wiggins
b. May 1848 d. 4 May 1920
12
Florence Conklin
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.7.10.1]
b. 1877 bur. 14 Aug 1894
12
Anna Bessie Conklin
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.7.10.2]
b. Apr 1877
12
Don J Conklin
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.7.10.3]
b. Oct 1880
12
Sarah C Conklin
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.7.10.4]
b. Sep 1888
11
Annette Conklin
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.7.11]
b. 1848 d. 22 Jun 1848
10
Ruth Wheelock Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.8]
b. 21 Sep 1807
William J Vermilyea
b. 7 Jul 1803 d. 30 Jun 1879
11
Francis Arvilla Vermilyea
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.8.1]
b. 19 Apr 1830 d. 19 Nov 1915
Isaac Fuller Camp
b. 11 Feb 1823 d. 10 Aug 1890
12
Edwin L Camp
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.8.1.1]
b. 13 Mar 1851
12
Ida M Vermilyea
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.8.1.2]
b. 8 Mar 1857
12
Hanna Ruth Camp
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.8.1.3]
b. 23 Apr 1859
12
Albert E Camp
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.8.1.4]
b. Nov 1862
12
Mary A Camp
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.8.1.5]
b. 1864
12
William Whitney Camp
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.8.1.6]
b. 5 Feb 1867
11
Emily Benson Vermilyea
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.8.2]
b. 6 Dec 1831 d. Jun 1902
William Henry Myers
b. 1827
12
William Franklin Myers
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.8.2.1]
b. 1855
12
Selina Delphenie Myers
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.8.2.2]
b. 1857
12
Elizabeth Lorma Myers
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.8.2.3]
b. 1860
12
Henrietta Lorma Myers
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.8.2.4]
b. 1862
12
Harriet Benson Myers
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.8.2.5]
b. 1869
12
Gertrude Lucinia Myers
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.8.2.6]
b. 1874
11
Sidney Smith Vermilyea
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.8.3]
b. 27 Oct 1835 d. 22 Dec 1929
Amanda Fluke
b. 31 May 1842 d. 31 Mar 1937
12
Owen C Vermilyea
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.8.3.1]
b. 20 Jul 1864 d. 1919 [
=>
]
12
Henry Arthur Vermilyea
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.8.3.2]
b. 12 Mar 1867 [
=>
]
12
Bert Vermilyea
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.8.3.3]
b. 4 Dec 1868 [
=>
]
12
Charles E Vermilyea
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.8.3.4]
b. 15 Jan 1871 [
=>
]
12
Edgar L Vermilyea
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.8.3.5]
b. 12 Oct 1874 [
=>
]
12
Mary A Vermilyea
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.8.3.6]
b. 2 Feb 1880 d. Abt 1981
11
Elkanah Benson Vermilyea
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.8.4]
b. 9 Sep 1837 d. 31 May 1838
11
Chauncey Vermilyea
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.8.5]
b. 25 Mar 1839 d. 16 Jun 1863
11
Eliza Prudence Vermilyea
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.8.6]
b. 4 Apr 1842 d. 1923
James Tytler Johnstone
c. 18 Oct 1840 d. 1913
12
Harry Vermilyea Johnstone
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.8.6.1]
b. 1872
12
Elizabeth Winifred Johnstone
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.8.6.2]
b. 1873
12
James Charles Johnstone
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.8.6.3]
b. 1875
12
John Harvey Johnstone
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.8.6.4]
b. 1877
12
James Benson Johnstone
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.8.6.5]
b. 1880
12
Donald Denny Johnstone
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.8.6.6]
b. 1884
11
John Benson Vermilyea
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.8.7]
b. 26 May 1844
+
Mary Elizabeth Frizzle
b. 1848
11
Albert Gallatin Vermilyea
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.8.8]
b. 15 Sep 1846
Samantha Sophia Crawford
b. 1850
12
Lillie Alice Vermilyea
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.8.8.1]
b. 26 Sep 1872
12
Carl Crawford Vermilyea
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.8.8.2]
b. 1 Feb 1874 [
=>
]
12
Daughter Vermilyea
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.8.8.3]
b. 1877 d. 1877
10
Sarah Elizabeth Benson
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.9]
b. 1 Jul 1809 d. 20 Jul 1888
Leicester Dodge
b. 28 Apr 1808 d. 5 Sep 1843
11
Ermina P Dodge
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.9.1]
b. 14 Feb 1831
+
Rufus Moe
11
Henry Benson Dodge
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.9.2]
b. 3 Oct 1832 d. 16 Feb 1914
Sally Betsey Howard
b. 27 Dec 1834 d. 15 Dec 1919
12
Emaline Elizabeth Dodge
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.9.2.1]
b. 29 Dec 1861 d. 1932
12
Ezra Leicester Dodge
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.9.2.2]
b. 22 Nov 1863 d. 3 Dec 1950
12
Benson Henry Dodge
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.9.2.3]
b. 15 Jan 1867 d. 25 Jun 1931 [
=>
]
12
Susan Louisa Dodge
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.9.2.4]
b. 28 May 1868 d. 8 Oct 1913
12
Hattie Blanche Dodge
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.9.2.5]
b. 25 Jun 1870 d. 1944 [
=>
]
11
Flora Elizabeth Dodge
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.9.3]
b. 6 Nov 1834
+
Horace Richards
11
Sarah Janette Dodge
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.9.4]
b. 20 Sep 1836
11
Calista Augusta Dodge
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.9.5]
b. 23 Nov 1838 d. 29 Aug 1884
+
William Alexander Gunsaullus
b. 15 Jul 1835 d. 27 Aug 1871
11
Caroline Emelia Dodge
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.9.6]
b. 30 Aug 1841 d. 7 Dec 1913
William Hadcill Carr
b. 13 Dec 1836 d. 19 Mar 1909
12
Florence A Carr
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.9.6.1]
b. 22 Jan 1864 d. 17 Feb 1904
12
Arthur Elmer Carr
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.9.6.2]
b. 19 Jun 1867 d. 20 Oct 1943
11
Lester Lewis Dodge
[1.1.1.1.1.1.6.3.7.9.7]
b. 30 Oct 1843
8
Eleazar Wheelock
[1.1.1.1.1.1.6.4]
b. 31 Mar 1734 d. 31 Aug 1747
7
Rachel Taft
[1.1.1.1.1.1.7]
b. 1 Oct 1704 d. 1752
Uriah Thayer
b. 10 Sep 1706
8
Uriah Thayer
[1.1.1.1.1.1.7.1]
b. 16 Mar 1728 d. 1796
8
Ebenezer Thayer
[1.1.1.1.1.1.7.2]
b. 1731 d. 1775
8
Eleazer Thayer
[1.1.1.1.1.1.7.3]
b. 1733 d. 1755
8
Rachel Thayer
[1.1.1.1.1.1.7.4]
b. 19 Jun 1735 d. 1783
8
Martha Thayer
[1.1.1.1.1.1.7.5]
b. 1736 d. 1807
8
Simeon Thayer
[1.1.1.1.1.1.7.6]
b. 20 Oct 1739 d. 1764
7
Martha Taft
[1.1.1.1.1.1.8]
b. 15 Jun 1708 d. 6 Jan 1753
Joseph Benson
b. 14 Oct 1712 d. 24 Feb 1786
8
Moses Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1]
b. 20 May 1732 d. 3 Jul 1806
Eunice Holbrook
b. 9 Aug 1735 d. Aft 1790
9
Aaron Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.1]
b. 28 Oct 1753 d. 8 Jul 1827
Lydia Fairbanks
b. 1758 d. 30 Aug 1814
10
Alanson Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.1.1]
b. 1783 d. 7 Dec 1857
Lucina Lapham
b. Abt 1789 d. Nov 1853
11
Lucina Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.1.1.1]
b. 28 Jan 1832 d. 1 Jan 1916
10
Polly Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.1.2]
b. 9 Apr 1785 d. 3 Dec 1847
Ebenezer Balcom
b. 14 Apr 1783 d. 14 Oct 1836
11
Aaron Balcom
[1.1.1.1.1.1.8.1.1.2.1]
b. 1805
11
Joel Chapin Balcom
[1.1.1.1.1.1.8.1.1.2.2]
b. Abt 1807
11
Mary Balcom
[1.1.1.1.1.1.8.1.1.2.3]
b. Abt 1809
10
Aaron Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.1.3]
b. 10 Mar 1788
10
Ellis Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.1.4]
b. 13 Oct 1792 d. 31 Mar 1830
10
Lydia Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.1.5]
b. 15 Oct 1798
Arnold White
b. 5 Mar 1800
11
Charles White
[1.1.1.1.1.1.8.1.1.5.1]
b. 1825 d. 25 Mar 1899
Lucinda M Taft
b. 15 Mar 1826 d. 5 Mar 1906
12
Alice Maria White
[1.1.1.1.1.1.8.1.1.5.1.1]
b. 7 May 1865 d. 10 Dec 1892 [
=>
]
12
Walter Arnold White
[1.1.1.1.1.1.8.1.1.5.1.2]
b. 9 May 1869 [
=>
]
9
David Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.2]
b. 23 Dec 1756 d. 8 Mar 1847
Zilla Marsh
b. 29 Aug 1760 d. 18 Jan 1817
10
Jessie Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.2.1]
b. 14 Mar 1781 d. Abt 1846
Olive Wheeler
b. 14 Feb 1788 d. 24 Aug 1846
11
Alanson Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.2.1.1]
b. Abt 1807
11
Lyman David Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.2.1.2]
b. Abt 1808 d. 1884
11
Susanna Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.2.1.3]
b. 1809 d. 9 Jun 1825
11
Laura Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.2.1.4]
b. Abt 1809
11
Olive Maria Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.2.1.5]
b. 1810 d. 1885
11
L Lavina Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.2.1.6]
b. 10 Oct 1810
11
Lanson Wheeler Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.2.1.7]
b. 9 Dec 1813
11
Flora Zillah Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.2.1.8]
b. 27 Jul 1815 d. 25 Apr 1875
11
Lyman Daniel Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.2.1.9]
b. 21 Aug 1817
11
Addison Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.2.1.10]
b. 7 May 1822 d. 16 Jul 1873
11
Anderson Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.2.1.11]
b. 7 May 1822 d. 1898
10
Betsey Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.2.2]
b. 27 Jun 1782
10
Asenath Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.2.3]
b. 16 Feb 1784
10
Phineas Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.2.4]
b. 31 May 1785 d. 15 Mar 1835
Polly Lucretia Frost
b. 1787 d. 14 May 1864
11
Luman Austin Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.2.4.1]
b. 21 Nov 1812
11
Benjamin McClure Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.2.4.2]
b. 21 Oct 1816 d. Aug 1858
11
Phineas Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.2.4.3]
b. 21 Oct 1816
11
Paulina Lucretia Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.2.4.4]
b. 27 May 1820
11
Eliza Ann Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.2.4.5]
b. 30 Jan 1823
11
Merrill H Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.2.4.6]
b. 14 Feb 1826 d. 25 Dec 1880
10
Levina Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.2.5]
b. 6 Sep 1786
10
Cyrus Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.2.6]
b. 23 Dec 1787
10
Matilda Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.2.7]
b. 10 Apr 1789
10
David Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.2.8]
b. 10 Apr 1789 d. 19 Oct 1868
Lucinda Adams
b. 1792 d. 2 Apr 1836
11
Son Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.2.8.1]
b. 24 Mar 1818
11
Cyrus Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.2.8.2]
b. 15 Feb 1819 d. 1895
11
David E Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.2.8.3]
b. 19 Mar 1820 d. 28 Dec 1895
11
Sally A Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.2.8.4]
b. 10 Mar 1821 d. 31 Aug 1823
11
Edwin Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.2.8.5]
b. 16 Mar 1822 d. 11 Sep 1852
11
Enoch Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.2.8.6]
b. 4 May 1823 d. 1901
11
Elliot Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.2.8.7]
b. 3 Aug 1824
11
Hannah Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.2.8.8]
b. 12 Sep 1825
11
Henry H Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.2.8.9]
b. 30 Sep 1827
11
Mary Louisa Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.2.8.10]
b. 8 Apr 1830
11
George D Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.2.8.11]
b. 18 Nov 1831
11
Merrick C Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.2.8.12]
b. 25 Oct 1833 d. Abt 1860
10
Moses Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.2.9]
b. 1 Oct 1792
+
Mary Howard
10
Lewis Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.2.10]
b. 21 Jan 1794
+
Maria Atwood
b. 6 May 1801
10
Danford Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.2.11]
b. 1 Jul 1794 d. 14 Feb 1859
Content Adams
b. 9 Mar 1800 d. 25 Sep 1877
11
Danforth Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.2.11.1]
b. 2 Aug 1820 d. 25 Jul 1872
11
Luna Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.2.11.2]
b. 10 Jul 1822
11
Lumen P Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.2.11.3]
b. 11 Aug 1824
10
Willard Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.2.12]
b. 7 Apr 1797
10
Susannah Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.2.13]
b. 7 Oct 1798 d. 4 Jan 1817
10
Hannah Azuba Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.2.14]
b. 4 Jul 1801
10
Albey Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.2.15]
b. 27 Aug 1804
9
Keziah Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.3]
b. 1 Mar 1759 d. Abt 1800
9
Daniel Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.4]
b. 1 Jun 1761 d. 9 Oct 1854
Phebe Bugbee
b. 1762 d. 3 May 1855
10
Annie Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.4.1]
b. 28 Mar 1787
10
Daniel Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.4.2]
b. 18 May 1788
10
John Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.4.3]
b. 19 Mar 1789
10
Mary Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.4.4]
b. 28 May 1791
10
Ebenezer Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.4.5]
b. 4 Sep 1793 d. 11 Mar 1870
+
Lucinda
10
Melinda Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.4.6]
b. 25 Jul 1795
10
Orrison Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.4.7]
b. 31 Aug 1797 d. 24 Apr 1883
+
Mary Williams
b. 1800
10
Sally Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.4.8]
b. 30 Jul 1799
John Kneeland
b. Abt 1795
11
Ichabod Kneeland
[1.1.1.1.1.1.8.1.4.8.1]
b. Abt 1821
10
Arza Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.4.9]
b. 7 Jul 1803
10
James Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.4.10]
b. 3 Jan 1805
10
Chester Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.4.11]
b. 26 Jan 1807 d. 19 Aug 1889
Florilla Williams
b. 8 Sep 1806 d. 14 Dec 1889
11
Cyntha Elnora Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.4.11.1]
b. 3 Oct 1827
11
Ellen Mariah Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.4.11.2]
b. 22 Aug 1829
11
Harriet Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.4.11.3]
b. 20 Sep 1831
11
Arza Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.4.11.4]
b. 13 Jul 1833
11
Walter Williams Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.4.11.5]
b. 5 Apr 1835 d. 5 Feb 1905
11
Chester Seldin Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.4.11.6]
b. 27 Mar 1837
11
Henry E. Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.4.11.7]
b. 6 May 1839
11
Harlon Clinton Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.4.11.8]
b. 2 May 1841
11
Meredith Mosell Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.4.11.9]
b. 7 Apr 1843
11
Lucy Marion Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.4.11.10]
b. 5 Jun 1845 d. 12 Jul 1916
11
Herbert Leslie Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.4.11.11]
b. 5 Dec 1847
11
Florilla Ada Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.4.11.12]
b. 22 Dec 1851
10
Cynthia Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.4.12]
b. 16 Jan 1809
10
Fanny Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.4.13]
b. 2 Jun 1811
9
Peter Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.5]
b. 16 Jul 1763 d. 23 Mar 1854
9
Jesse Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.6]
b. 19 Feb 1766
9
Anna Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.7]
b. 6 Aug 1767
9
Hannah Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.8]
b. 3 Mar 1770
9
Susanna Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.9]
b. 26 Aug 1772
9
Eunice Benson
[1.1.1.1.1.1.8.1.10]
b. 4 May 1775
8
Joseph Benson, Jr
[1.1.1.1.1.1.8.2]
b. 22 Oct 1735 d. 12 Jan 1818
8
Aaron Benson
[1.1.1.1.1.1.8.3]
b. 20 May 1738 d. 7 Nov
8
Benjamin Benson
[1.1.1.1.1.1.8.4]
b. 3 Mar 1742 d. 29 Mar 1802
Martha McNamara
b. 11 Mar 1745 d. 15 Sep 1806
9
Amasa Benson
[1.1.1.1.1.1.8.4.1]
b. 15 Mar 1770 d. 28 Oct 1777
9
Timothy Benson
[1.1.1.1.1.1.8.4.2]
b. 19 Aug 1771 d. 22 Oct 1777
9
Silence Benson
[1.1.1.1.1.1.8.4.3]
b. 30 Jul 1773 d. 10 Nov 1777
9
Hannah Benson
[1.1.1.1.1.1.8.4.4]
b. 18 Apr 1775 d. 22 Apr 1831
+
Asahel Pelton
b. 3 Aug 1773 d. 27 Mar 1857
9
Martha Benson
[1.1.1.1.1.1.8.4.5]
b. 26 Feb 1777
Timatha Gleason
b. 2 Aug 1779 d. 4 May 1841
10
Lucy Gleason
[1.1.1.1.1.1.8.4.5.1]
b. 2 Feb 1804
+
Curtis P Howe
10
Mary Gleason
[1.1.1.1.1.1.8.4.5.2]
b. 23 Jul 1807
+
Wyman Fay
10
Fidelia Gleason
[1.1.1.1.1.1.8.4.5.3]
b. 9 Jan 1811 d. Bef 1922
+
Lorin Davis
b. 1809
10
George G Gleason
[1.1.1.1.1.1.8.4.5.4]
b. 27 Aug 1815
10
Martha Ann Gleason
[1.1.1.1.1.1.8.4.5.5]
b. 16 Sep 1821
10
Martha Gleason
[1.1.1.1.1.1.8.4.5.6]
b. 27 Sep 1822
9
Amasa Benson
[1.1.1.1.1.1.8.4.6]
b. 15 Feb 1779 d. 22 Feb 1847
9
Silence Benson
[1.1.1.1.1.1.8.4.7]
b. 8 Aug 1781 d. 4 Sep 1829
+
Clark Adams
b. 5 Nov 1773
9
Thankful Benson
[1.1.1.1.1.1.8.4.8]
b. 29 Aug 1783 d. 11 Apr 1808
Otis Taft
b. 17 Sep 1786 d. 19 Nov 1827
10
Tilus Vespasian Taft
[1.1.1.1.1.1.8.4.8.1]
b. 4 Jun 1806 d. 22 Feb 1889
Sarah Jane Hagar
b. 16 Dec 1810 d. 25 Sep 1852
11
Louis V Taft
[1.1.1.1.1.1.8.4.8.1.1]
b. 2 Oct 1831
11
Abby Jane Taft
[1.1.1.1.1.1.8.4.8.1.2]
b. 30 Oct 1836 d. 1906
11
Georgiana Taft
[1.1.1.1.1.1.8.4.8.1.3]
b. 31 Mar 1839 d. 9 Oct 1918
11
James K Polk Taft
[1.1.1.1.1.1.8.4.8.1.4]
b. 17 May 1847 d. 15 Sep 1847
11
Sarah Taft
[1.1.1.1.1.1.8.4.8.1.5]
b. 21 Sep 1852 d. 21 Sep 1852
Katharine Edwards
b. 22 Dec 1815 d. 22 Feb 1878
11
Henry Taft
[1.1.1.1.1.1.8.4.8.1.6]
b. 12 Nov 1854 d. 12 Nov 1854
11
Edward Taft
[1.1.1.1.1.1.8.4.8.1.7]
b. 7 Feb 1858 d. 9 May 1930
10
Benjamin B Taft
[1.1.1.1.1.1.8.4.8.2]
b. 28 Feb 1808
9
Benjamin Benson
[1.1.1.1.1.1.8.4.9]
b. 6 Jun 1786 d. 18 Mar 1815
9
Truelove Benson
[1.1.1.1.1.1.8.4.10]
b. 18 Nov 1788 d. 1 Aug 1837
+
Jonas Johnson
8
Abner Benson
[1.1.1.1.1.1.8.5]
b. Abt 1750
Experience Muxsom
b. 1753
9
Martha Benson
[1.1.1.1.1.1.8.5.1]
b. 27 Oct 1771 d. 7 Dec 1850
David Davis
b. 16 Oct 1767 d. 19 Nov 1811
10
Lucy Davis
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.1]
b. 14 Apr 1791 d. 1822
Elisha Snell
11
Lucy Attie Shell
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.1.1]
b. 1 Oct 1813
Lorenzo H Earle
b. 16 Jul 1808 d. 12 Apr 1882
12
Mary A Earle
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.1.1.1]
b. 3 Nov 1837 d. 16 Oct 1838
12
Oceana L Earle
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.1.1.2]
b. 8 Jun 1839 d. 25 Nov 1840
12
Lorenzo H Earle
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.1.1.3]
b. 11 Jan 1841 d. 13 Feb 1842
12
Tyler Lorenzo Earle
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.1.1.4]
b. 5 Mar 1842 d. 3 May 1909
12
Ellen M Earle
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.1.1.5]
b. 18 Jun 1843
12
Mary Earle
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.1.1.6]
b. 3 Aug 1845
12
Arvilla L Earle
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.1.1.7]
b. 17 May 1848
12
Philaro R Earle
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.1.1.8]
b. 29 Sep 1851
12
Jane A Earle
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.1.1.9]
b. 31 Aug 1855 d. 24 Dec 1856
12
James A Earle
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.1.1.10]
b. 31 Aug 1855 d. 3 Dec 1856
10
David Davis
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.2]
b. 21 Dec 1792
Roxanna Barr
b. 13 Feb 1790
11
William Davis
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.2.1]
b. 26 Oct 1810
+
Hepzabath Wood
b. Abt 1821
11
Hosiah Davis
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.2.2]
b. 4 May 1812
+
Maria Walker
b. 18 Feb 1813
11
Charles Davis
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.2.3]
b. 17 Sep 1814
+
Eliza Gibbs
b. Abt 1815
Lucinda Mundell
b. 11 Dec 1817
12
Charles Henry Davis
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.2.3.1]
b. 8 Mar 1840
12
George Hamilton Davis
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.2.3.2]
b. 11 Mar 1842
12
Franklin Edward Davis
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.2.3.3]
b. 16 Dec 1843
12
Charles Henry Davis
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.2.3.4]
b. 16 Dec 1844
12
Ginery Twitchell Davis
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.2.3.5]
b. 27 Nov 1846
11
Sarah Davis
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.2.4]
b. 10 Aug 1816
William G. Hall
b. Abt 1812
12
Edward Parsons Hall
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.2.4.1]
b. 3 Jan 1842
11
Sally Davis
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.2.5]
b. 10 Aug 1816
11
Mary Davis
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.2.6]
b. 5 May 1819
Patrick Fitzgerald
b. Abt 1815
12
John Fitzgerald
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.2.6.1]
b. 12 Jun 1846
Elizabeth Clark Spaulding
b. 1799 d. 21 Dec 1872
11
Philena Laurette Davis
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.2.7]
b. 11 Feb 1822 d. 22 Jan 1903
11
Suel Spaulding Davis
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.2.8]
b. 30 Mar 1824 d. 27 Apr 1904
11
Lyman Uberto Davis
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.2.9]
b. Abt 1826
11
William Clark Davis
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.2.10]
b. Abt 1830
11
John Warren Davis
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.2.11]
b. Abt 1831 d. 6 Oct 1913
11
Susan Almirao Davis
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.2.12]
b. 11 Nov 1834 d. 20 Nov 1903
11
George Willoughby Davis
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.2.13]
b. 18 Nov 1839
11
Theresa Isadore Davis
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.2.14]
b. Abt 19 Jun 1846 d. 13 Oct 1924
11
David Gordon Davis
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.2.15]
10
Hiram Davis
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.3]
b. Abt 1793
Eliza H Wheeler
b. 24 Feb 1799
11
William Davis
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.3.1]
b. 1819 d. 20 Jan 1821
11
Caroline Davis
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.3.2]
b. 1820
11
Martha Davis
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.3.3]
b. 1820
11
Francis Davis
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.3.4]
b. 1820
11
Geroge Davis
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.3.5]
b. 1820
10
Abner Davis
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.4]
b. 21 Sep 1795 d. 10 Dec 1874
Lucy Oaks
b. Abt 1794 d. 1827
11
Harriet C Davis
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.4.1]
b. 13 Nov 1821 d. 3 Aug 1887
11
Andrew J Davis
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.4.2]
b. 1826 d. 10 Mar 1910
11
Sarah Y Davis
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.4.3]
b. 13 Mar 1829 d. 15 Dec 1916
11
Frances Carolyn Davis
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.4.4]
b. 2 Nov 1833 d. 30 Aug 1885
10
Suel Davis
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.5]
b. 13 Apr 1798 d. 28 Sep 1872
Lucy Wheeler
b. 5 Oct 1792 d. 27 Mar 1860
11
Charles C Davis
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.5.1]
b. 6 Nov 1822 d. 4 Apr 1903
+
Sarah Brooks
d. 22 Feb 1879
11
Edwin Davis
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.5.2]
b. 1824
9
Lucy Benson
[1.1.1.1.1.1.8.5.2]
b. 16 Apr 1774 d. 11 Dec 1815
9
Dennis Benson
[1.1.1.1.1.1.8.5.3]
b. 24 Jan 1777
7
Isaac Taft
[1.1.1.1.1.1.9]
b. 15 Jul 1710 d. 11 Oct 1776
Deborah White
b. 1711
8
Isaac Taft
[1.1.1.1.1.1.9.1]
b. 1743
8
Jonathan Taft
[1.1.1.1.1.1.9.2]
b. 5 Jan 1745 d. 1810
8
Artemas Taft
[1.1.1.1.1.1.9.3]
b. 28 Dec 1750 d. 1 Aug 1837
8
Susannah Taft
[1.1.1.1.1.1.9.4]
b. 1753 d. 2 Apr 1819
8
Timothy Taft
[1.1.1.1.1.1.9.5]
b. 1757 d. 1824
8
Mary Taft
[1.1.1.1.1.1.9.6]
b. 1761
7
Thomas Taft
[1.1.1.1.1.1.10]
b. 5 Apr 1713 d. 25 Jan 1793
Lydia Thompson
b. 10 Dec 1710 d. Aft 1756
8
Thomas Taft
[1.1.1.1.1.1.10.1]
b. 14 May 1736 d. 15 May 1736
8
Kezia Taft
[1.1.1.1.1.1.10.2]
b. 7 May 1737 d. 3 Jul 1737
8
Lydia Taft
[1.1.1.1.1.1.10.3]
b. 18 May 1738 d. 29 Jan 1829
8
Charity Taft
[1.1.1.1.1.1.10.4]
b. 24 Nov 1742 d. 22 Aug 1747
8
Hannah Taft
[1.1.1.1.1.1.10.5]
b. 6 Mar 1745
8
Nathaniel Taft
[1.1.1.1.1.1.10.6]
b. 15 Oct 1747 d. 12 Aug 1827
8
Amariah Taft
[1.1.1.1.1.1.10.7]
b. 13 Feb 1750 d. 2 Mar 1750
8
Thomas Taft, Jr
[1.1.1.1.1.1.10.8]
b. 30 Oct 1753 d. 8 Jan 1835
Betsey Fletcher
b. 1772 d. 20 Sep 1819
9
Thomas Arnold Taft
[1.1.1.1.1.1.10.8.1]
b. 22 May 1794 d. 16 Apr 1871
Martha Willard Harrington
b. 16 Sep 1797 d. 10 Jan 1888
10
Betsey Willard Taft
[1.1.1.1.1.1.10.8.1.1]
b. 28 Nov 1815
10
Charlott Taft
[1.1.1.1.1.1.10.8.1.2]
b. 7 Jul 1817 d. 22 Feb 1883
10
Lewis Willard Taft
[1.1.1.1.1.1.10.8.1.3]
b. 19 May 1819
10
Arnold Austin Taft
[1.1.1.1.1.1.10.8.1.4]
b. 31 Dec 1820 d. 22 May 1853
10
George Taft
[1.1.1.1.1.1.10.8.1.5]
b. 10 Apr 1822 d. 7 Dec 1852
10
David Henry Taft
[1.1.1.1.1.1.10.8.1.6]
b. 31 Dec 1823
10
Martha Taft
[1.1.1.1.1.1.10.8.1.7]
b. 23 Feb 1826 d. 19 Feb 1903
Jared Benson
b. 8 Nov 1821 d. 18 May 1894
11
Sullivan Theodore Benson
[1.1.1.1.1.1.10.8.1.7.1]
b. 20 Apr 1844 d. 21 Sep 1911
11
Jared Irving Benson
[1.1.1.1.1.1.10.8.1.7.2]
b. 6 Oct 1846 d. 1919
Jenny Aiken Guild
b. 1852 d. 27 Oct 1906
12
Jared Curtis Benson
[1.1.1.1.1.1.10.8.1.7.2.1]
b. 6 Oct 1877
12
Frank Theodore Benson
[1.1.1.1.1.1.10.8.1.7.2.2]
b. 25 Feb 1878 d. Jul 1949 [
=>
]
11
Walter Bryant Benson
[1.1.1.1.1.1.10.8.1.7.3]
b. 16 Jan 1850 d. 10 Feb 1860
11
Grace Sally Benson
[1.1.1.1.1.1.10.8.1.7.4]
b. 2 Sep 1852 d. 25 Feb 1863
10
Stephen Claridon Taft
[1.1.1.1.1.1.10.8.1.8]
b. 30 Sep 1827 d. 23 Jan 1905
10
Charles Taft
[1.1.1.1.1.1.10.8.1.9]
b. 4 Oct 1829
10
Adin Ballou Taft
[1.1.1.1.1.1.10.8.1.10]
b. 7 Nov 1831
10
Waterman Taft
[1.1.1.1.1.1.10.8.1.11]
b. 13 Nov 1833
10
James Edward Taft
[1.1.1.1.1.1.10.8.1.12]
b. 4 Apr 1836
10
Jane Ellen Taft
[1.1.1.1.1.1.10.8.1.13]
b. 4 Apr 1836
10
Anna Sophia Taft
[1.1.1.1.1.1.10.8.1.14]
b. 7 Jul 1839
10
Julia August Freemon Taft
[1.1.1.1.1.1.10.8.1.15]
b. 29 Mar 1841 d. 15 Nov 1842
9
Stephen Taft
[1.1.1.1.1.1.10.8.2]
b. 30 Nov 1795
9
Thomas Taft, Jr
[1.1.1.1.1.1.10.8.3]
b. 26 Dec 1797 d. 24 Sep 1872
9
Betsey Taft
[1.1.1.1.1.1.10.8.4]
b. 7 Oct 1804
8
Genery Taft
[1.1.1.1.1.1.10.9]
b. 3 Jun 1756 d. 17 Aug 1761
7
Susanna Taft
[1.1.1.1.1.1.11]
b. 15 Mar 1714 d. 8 Nov 1751
John Fish
b. 30 Jun 1715 d. Aft 1772
8
Deborah Fish
[1.1.1.1.1.1.11.1]
b. 13 Feb 1741 d. 5 Mar 1826
8
Hannah Fish
[1.1.1.1.1.1.11.2]
b. 25 Jun 1744 d. 20 Sep 1836
8
Simeon Fish
[1.1.1.1.1.1.11.3]
b. 1747 d. 1825
8
Lydia Fish
[1.1.1.1.1.1.11.4]
b. 8 Sep 1749
8
John Fish
[1.1.1.1.1.1.11.5]
b. 7 Nov 1751 d. 7 Nov 1751
6
Robert Taft Jr
[1.1.1.1.1.2]
b. Abt 1674 d. 29 Apr 1748
Elizabeth Woodward
b. 15 Jun 1670 d. 7 Aug 1753
7
Robert Taft
[1.1.1.1.1.2.1]
b. 24 Dec 1697 d. 6 Mar 1776
Mary Chapin
b. 30 Apr 1700 d. 22 Jan 1768
8
Bethiah Taft
[1.1.1.1.1.2.1.1]
b. 21 Dec 1721 d. 30 May 1741
8
Elizabeth Taft
[1.1.1.1.1.2.1.2]
b. 18 Jun 1723 d. 1779
8
Deborah Keith
[1.1.1.1.1.2.1.3]
b. 20 Feb 1728 d. 11 Apr 1806
8
Seth Taft
[1.1.1.1.1.2.1.4]
b. 27 Oct 1729 d. 15 Feb 1794
8
Jesse Taft
[1.1.1.1.1.2.1.5]
b. 4 Apr 1731 d. 1753
8
Abigail Taft
[1.1.1.1.1.2.1.6]
b. 20 Jan 1737
8
Ebenezer Taft
[1.1.1.1.1.2.1.7]
b. 8 Aug 1732 d. 3 Oct 1836
Polly Hayward
b. 10 Oct 1760 d. 15 Aug 1848
9
Enos Taft
[1.1.1.1.1.2.1.7.1]
b. 8 Dec 1779 d. 29 Dec 1812
9
Betsey Taft
[1.1.1.1.1.2.1.7.2]
b. 11 Jun 1781
9
Putman Taft
[1.1.1.1.1.2.1.7.3]
b. 5 Aug 1783 d. 20 Feb 1810
Abigail Benson
b. 13 Feb 1787
10
Mary Ann Taft
[1.1.1.1.1.2.1.7.3.1]
b. 23 Oct 1807
+
Samuel T Holroyd
b. 1791 d. 4 Nov 1817
+
Angel Sweet
b. 7 Apr 1790 d. 28 Apr 1825
+
Edward Ide Bower
+
Joseph McDermott
9
Polly Taft
[1.1.1.1.1.2.1.7.4]
b. 20 Jun 1785
9
Salley Taft
[1.1.1.1.1.2.1.7.5]
b. 21 Oct 1787 d. 7 Aug 1855
Jared Benson
b. 3 Feb 1785 d. 31 Jul 1854
10
James Sulliven Benson
[1.1.1.1.1.2.1.7.5.1]
b. 19 Sep 1808 d. 3 Jan 1833
10
Putman Taft Benson
[1.1.1.1.1.2.1.7.5.2]
b. 28 Oct 1814 d. 24 Apr 1834
10
Jared Benson
[1.1.1.1.1.2.1.7.5.3]
b. 8 Nov 1821 d. 18 May 1894
Martha Taft
b. 23 Feb 1826 d. 19 Feb 1903
11
Sullivan Theodore Benson
[1.1.1.1.1.2.1.7.5.3.1]
b. 20 Apr 1844 d. 21 Sep 1911
11
Jared Irving Benson
[1.1.1.1.1.2.1.7.5.3.2]
b. 6 Oct 1846 d. 1919
Jenny Aiken Guild
b. 1852 d. 27 Oct 1906
12
Jared Curtis Benson
[1.1.1.1.1.2.1.7.5.3.2.1]
b. 6 Oct 1877
12
Frank Theodore Benson
[1.1.1.1.1.2.1.7.5.3.2.2]
b. 25 Feb 1878 d. Jul 1949 [
=>
]
11
Walter Bryant Benson
[1.1.1.1.1.2.1.7.5.3.3]
b. 16 Jan 1850 d. 10 Feb 1860
11
Grace Sally Benson
[1.1.1.1.1.2.1.7.5.3.4]
b. 2 Sep 1852 d. 25 Feb 1863
10
Sylvanus Holbrook Benson
[1.1.1.1.1.2.1.7.5.4]
b. 23 Jun 1828 d. 1878
Laurett V Howard
b. 1830 d. 1860
11
Ellen Laura Benson
[1.1.1.1.1.2.1.7.5.4.1]
b. 18 Aug 1851
George Hawes Lapham
b. 12 Jul 1849
12
Hattie Cobb Lapham
[1.1.1.1.1.2.1.7.5.4.1.1]
b. 21 Oct 1873 d. 13 Jun 1906
12
Albert Francis Lapham
[1.1.1.1.1.2.1.7.5.4.1.2]
b. 11 Dec 1876 [
=>
]
12
Frank Atwood Lapham
[1.1.1.1.1.2.1.7.5.4.1.3]
b. 2 Oct 1878
12
Frederick Lapham
[1.1.1.1.1.2.1.7.5.4.1.4]
b. 2 Sep 1880
12
Daughter Lapham
[1.1.1.1.1.2.1.7.5.4.1.5]
b. 19 Nov 1882
12
William Lapham
[1.1.1.1.1.2.1.7.5.4.1.6]
b. 29 Apr 1884 d. Bef 1890
12
Teresa Lapham
[1.1.1.1.1.2.1.7.5.4.1.7]
b. 10 Dec 1886
12
William Lapham
[1.1.1.1.1.2.1.7.5.4.1.8]
b. 5 Nov 1890 d. 24 May 1898
11
Ernest S Benson
[1.1.1.1.1.2.1.7.5.4.2]
b. 25 May 1855
+
Ida Cornelia Furbish
b. 1858
11
Laurett Victoria Howard Benson
[1.1.1.1.1.2.1.7.5.4.3]
b. 1859 d. 3 Jul 1883
Ezra Hunt Bailey
b. 23 Dec 1853 d. 3 May 1929
12
Edith L Bailey
[1.1.1.1.1.2.1.7.5.4.3.1]
b. 19 Jan 1881 d. 1962
Lottie E. Kelly
11
Lottie E. Benson
[1.1.1.1.1.2.1.7.5.4.4]
b. 20 Sep 1866
9
Chloe Taft
[1.1.1.1.1.2.1.7.6]
b. 7 Nov 1789
9
Deborah Taft
[1.1.1.1.1.2.1.7.7]
b. 21 Feb 1791 d. 14 Feb 1813
9
Leonard Taft
[1.1.1.1.1.2.1.7.8]
b. 17 Jun 1794 d. 25 Sep 1872
Martha Comstock
b. 17 Nov 1798 d. 14 May 1853
10
Hannah Mariah Taft
[1.1.1.1.1.2.1.7.8.1]
b. 11 Jul 1824 d. 31 Jul 1844
10
Enos Nelson Taft
[1.1.1.1.1.2.1.7.8.2]
b. 12 Aug 1826
10
Leonard Almond Taft
[1.1.1.1.1.2.1.7.8.3]
b. 22 Jul 1828 d. 29 Jul 1857
10
Edward Henry Taft
[1.1.1.1.1.2.1.7.8.4]
b. 1 Jul 1830
9
Phila Taft
[1.1.1.1.1.2.1.7.9]
b. 25 Mar 1796 d. 26 Mar 1813
9
Ellis Taft
[1.1.1.1.1.2.1.7.10]
b. 23 May 1796 d. 27 Aug 1851
+
Aseneth Boyden
b. 10 Sep 1794 d. Apr 1886
9
Nancy Taft
[1.1.1.1.1.2.1.7.11]
b. 14 Aug 1801 d. 14 Jan 1849
7
Israel Taft
[1.1.1.1.1.2.2]
b. 26 Apr 1699 d. 19 Sep 1753
Mercy Aldrich
b. 21 Jun 1700 d. Aft 19 Sep 1753
8
Huldah Taft
[1.1.1.1.1.2.2.1]
b. 28 Jun 1718 d. 2 Jul 1799
David Daniels
b. 4 Jul 1710 d. 21 May 1776
9
Ruth Daniels
[1.1.1.1.1.2.2.1.1]
b. 13 Jul 1738 d. 26 Sep 1798
Jonathan Wheelock
b. 8 Sep 1731 d. 1774
10
Eleazer Wheelock
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.1]
b. 15 Jul 1756 d. 1841
10
Dole Wheelock
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.2]
b. 29 May 1758
10
Susannah Wheelock
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.3]
b. 23 Feb 1760 d. 2 May 1776
10
Lyman Wheelock
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.4]
b. 30 Nov 1761 d. 29 Mar 1848
10
Alphaeus Wheelock
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.5]
b. 17 Dec 1763
10
Willard Wheelock
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.6]
b. 19 Jun 1768 d. 29 Mar 1823
10
Deobrah Wheelock
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7]
b. 17 Dec 1765 d. 3 Aug 1846
Elkanah Benson
b. 21 Feb 1766 d. 8 Mar 1844
11
Samuel Benson
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.1]
b. 21 May 1791
Mary Van Liew
b. 8 Jul 1797 d. 22 Apr 1859
12
William Benson
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.1.1]
b. 18 Dec 1817
12
Emily Benson
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.1.2]
b. 18 Dec 1817
12
Alzina Benson
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.1.3]
b. 8 Nov 1819 d. 29 Mar 1867
12
Augustus Benson
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.1.4]
b. 10 Feb 1822
12
Phila Benson
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.1.5]
b. 8 Mar 1824 [
=>
]
12
Nathan S Benson
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.1.6]
b. 17 Sep 1826 d. 1869 [
=>
]
12
James Mapes Benson
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.1.7]
b. 12 Jun 1828 d. 11 Oct 1907 [
=>
]
12
Montgomery Benson
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.1.8]
b. Abt 1833
12
Mary Ellen Benson
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.1.9]
b. Abt 1839
11
Chloe Benson
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.2]
b. 6 Jan 1793 d. 1882
Lewis Smith
b. Abt 1790
12
Mary Smith
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.2.1]
b. Abt 1813 d. 1913
12
Sidney Smith
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.2.2]
b. 29 Jan 1815 d. 10 Sep 1900 [
=>
]
12
William Smith
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.2.3]
b. Abt 1817
12
Lewis Smith
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.2.4]
b. Abt 1820
12
Stephen Smith
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.2.5]
b. 19 Feb 1823 d. 26 Aug 1922 [
=>
]
12
Job Lewis Smith
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.2.6]
b. 15 Oct 1827 d. 9 Jun 1897
11
Adolphus Willard Benson
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.3]
b. 17 Dec 1795 d. 18 May 1878
Hannah Vermilyea
b. 1796 d. 28 Jun 1886
12
Edward Benson
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.3.1]
b. 1824
12
Bryon L Benson
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.3.2]
b. 25 Dec 1825 d. 23 Oct 1912 [
=>
]
12
Lewis Benson
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.3.3]
b. Abt 1827
12
Elizabeth Benson
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.3.4]
b. Abt 1829
12
Ellen Benson
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.3.5]
b. Abt 1831
12
John Benson
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.3.6]
b. Abt 1833
12
Henry Benson
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.3.7]
b. Abt 1835
12
Jane H Benson
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.3.8]
b. Abt 1837
12
Frank Benson
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.3.9]
b. Abt 1839
11
Eliza Benson
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.4]
b. 9 Mar 1798 d. 13 Nov 1817
+
James Miller
b. Abt 1795
11
Leonard Benson
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.5]
b. 7 Apr 1800 d. 7 Sep 1877
Ruth Ann Reynolds
b. 23 Jul 1805 d. 2 Feb 1853
12
Elisha Benson
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.5.1]
b. 1829 [
=>
]
12
William R Benson
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.5.2]
b. 1831 d. 26 Feb 1889 [
=>
]
12
John Thompson Benson
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.5.3]
b. 25 May 1833 d. 2 Apr 1914 [
=>
]
12
Emory J Benson
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.5.4]
b. Jul 1836 d. 8 Mar 1926 [
=>
]
12
Finley E Benson
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.5.5]
b. Abt 1841 [
=>
]
Hannah Sherman
12
Mary Isabelle Benson
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.5.6]
b. 7 Jun 1853 d. 9 Dec 1935 [
=>
]
11
Phila Benson
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.6]
b. 27 Jul 1802
Charles Warner
b. Abt 1800
12
Susan Warner
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.6.1]
b. 1828
12
Mary Warner
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.6.2]
b. 1830
12
Harriet Warner
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.6.3]
b. 1832
11
Calista Benson
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.7]
b. 2 Jun 1804 d. 15 Sep 1882
Jacob Conklin
b. 19 Sep 1798 d. 1 Nov 1884
12
Sarah Conklin
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.7.1]
b. 1828
12
Edward Conklin
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.7.2]
b. Abt 1828
12
Sory Ann Conklin
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.7.3]
b. 1831 d. 7 Feb 1832
12
Benson Conklin
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.7.4]
b. May 1833 [
=>
]
12
John Conklin
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.7.5]
b. 1835 d. 25 Oct 1835
12
Maria Conklin
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.7.6]
b. 1837 d. 1850
12
Daughter Conklin
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.7.7]
b. 1840 d. 1840
12
Eugene Conklin
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.7.8]
b. 1841 d. 14 Apr 1912 [
=>
]
12
Daughter Conklin
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.7.9]
b. 1843 d. 3 Mar 1843
12
Lewis Smith Conklin
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.7.10]
b. Nov 1845 d. 28 Feb 1905 [
=>
]
12
Annette Conklin
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.7.11]
b. 1848 d. 22 Jun 1848
11
Ruth Wheelock Benson
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.8]
b. 21 Sep 1807
William J Vermilyea
b. 7 Jul 1803 d. 30 Jun 1879
12
Francis Arvilla Vermilyea
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.8.1]
b. 19 Apr 1830 d. 19 Nov 1915 [
=>
]
12
Emily Benson Vermilyea
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.8.2]
b. 6 Dec 1831 d. Jun 1902 [
=>
]
12
Sidney Smith Vermilyea
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.8.3]
b. 27 Oct 1835 d. 22 Dec 1929 [
=>
]
12
Elkanah Benson Vermilyea
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.8.4]
b. 9 Sep 1837 d. 31 May 1838
12
Chauncey Vermilyea
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.8.5]
b. 25 Mar 1839 d. 16 Jun 1863
12
Eliza Prudence Vermilyea
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.8.6]
b. 4 Apr 1842 d. 1923 [
=>
]
12
John Benson Vermilyea
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.8.7]
b. 26 May 1844
12
Albert Gallatin Vermilyea
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.8.8]
b. 15 Sep 1846 [
=>
]
11
Sarah Elizabeth Benson
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.9]
b. 1 Jul 1809 d. 20 Jul 1888
Leicester Dodge
b. 28 Apr 1808 d. 5 Sep 1843
12
Ermina P Dodge
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.9.1]
b. 14 Feb 1831
12
Henry Benson Dodge
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.9.2]
b. 3 Oct 1832 d. 16 Feb 1914 [
=>
]
12
Flora Elizabeth Dodge
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.9.3]
b. 6 Nov 1834
12
Sarah Janette Dodge
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.9.4]
b. 20 Sep 1836
12
Calista Augusta Dodge
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.9.5]
b. 23 Nov 1838 d. 29 Aug 1884
12
Caroline Emelia Dodge
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.9.6]
b. 30 Aug 1841 d. 7 Dec 1913 [
=>
]
12
Lester Lewis Dodge
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.7.9.7]
b. 30 Oct 1843
Abraham Staples
b. 4 Apr 1731 d. 20 Oct 1803
10
Ruth Staples
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.8]
b. 22 Feb 1775 d. 10 Aug 1851
Elias Thayer
b. 3 May 1773 d. 26 Jun 1833
11
Hannah Ellis Thayer
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.8.1]
b. 19 Mar 1800 d. 26 Feb 1818
Charles Benson Jenckes
b. 10 Apr 1796 d. Aft 1831
12
Charles T Jenckes
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.8.1.1]
b. 20 Feb 1818 d. 28 Feb 1818
11
Ruth Daniels Thayer
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.8.2]
b. 16 Jul 1802
11
Mary Blake Thayer
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.8.3]
b. 26 Nov 1804 d. 1870
11
Elias Thayer
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.8.4]
b. 28 Oct 1806 d. 2 Nov 1808
11
Julia Ann Thayer
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.8.5]
b. 13 Dec 1808 d. 6 Aug 1833
11
Lyman Wheelock Thayer
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.8.6]
b. 6 May 1798 d. 5 Apr 1848
11
Susan Thayer
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.8.7]
b. 1 Feb 1811 d. 7 Apr 1812
11
Elias Nelson Thayer
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.8.8]
b. 3 Apr 1814 d. 6 Aug 1835
11
John Milton Thayer
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.8.9]
b. 24 Jan 1820 d. 19 Mar 1906
10
Lendol Staples
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.9]
b. 1777
10
Susannah Staples
[1.1.1.1.1.2.2.1.1.10]
b. 21 Jul 1780 d. 11 Feb 1818
9
Daniel Daniels
[1.1.1.1.1.2.2.1.2]
b. 4 Nov 1740 d. 24 May 1832
Ruth Aldrich
b. 29 Jun 1741 d. 15 Jul 1801
10
Rachael Daniels
[1.1.1.1.1.2.2.1.2.1]
b. 24 Dec 1767 d. 11 Aug 1846
10
Nathan Daniels
[1.1.1.1.1.2.2.1.2.2]
b. 1769 d. 10 May 1839
10
Dianah Daniels
[1.1.1.1.1.2.2.1.2.3]
b. 1774
10
Hulda Daniels
[1.1.1.1.1.2.2.1.2.4]
b. 1776
10
Adolpheus Daniels
[1.1.1.1.1.2.2.1.2.5]
b. 1778
10
Waite Daniels
[1.1.1.1.1.2.2.1.2.6]
b. 1780
+
Nancy Thayer
b. Abt 1743 d. 10 Mar 1803
9
Molly Daniels
[1.1.1.1.1.2.2.1.3]
b. 1 Oct 1741 d. 13 Apr 1793
Seth Kelley
b. 26 Nov 1730 d. 29 Apr 1799
10
Seth Kelley
[1.1.1.1.1.2.2.1.3.1]
b. 10 Sep 1762 d. 27 Sep 1850
10
Mehitable Kelley
[1.1.1.1.1.2.2.1.3.2]
b. 30 Apr 1765 d. 4 Nov 1798
10
Lettice Kelley
[1.1.1.1.1.2.2.1.3.3]
b. 9 Jan 1768 d. 1 Feb 1843
10
Willis Kelley
[1.1.1.1.1.2.2.1.3.4]
b. 14 Jan 1770 d. 23 Dec 1826
10
Moses Kelley
[1.1.1.1.1.2.2.1.3.5]
b. 19 Oct 1771 d. 14 Sep 1776
10
Waite Kelley
[1.1.1.1.1.2.2.1.3.6]
b. 12 Aug 1773 d. 7 Mar 1781
10
Asa Kelley
[1.1.1.1.1.2.2.1.3.7]
b. 24 Mar 1775 d. 29 Apr 1852
10
John Kelley
[1.1.1.1.1.2.2.1.3.8]
b. 12 Dec 1776 d. 17 Aug 1866
10
Daniel Kelley
[1.1.1.1.1.2.2.1.3.9]
b. 23 Jul 1778 d. 23 Apr 1825
10
Mary Kelley
[1.1.1.1.1.2.2.1.3.10]
b. 6 Jul 1780 d. 26 Feb 1802
10
Mark Kelley
[1.1.1.1.1.2.2.1.3.11]
b. 1783 d. 12 Feb 1852
10
Hulda Kelley
[1.1.1.1.1.2.2.1.3.12]
b. 1 Mar 1785 d. 29 Mar 1785
10
David Kelly
[1.1.1.1.1.2.2.1.3.13]
b. 1786
9
Azor Daniels
[1.1.1.1.1.2.2.1.4]
b. 20 Feb 1743 d. 19 Sep 1748
9
Chloe Daniels
[1.1.1.1.1.2.2.1.5]
b. 13 Sep 1745 d. 19 May 1823
Seth Davenport
b. 2 Nov 1739 d. 28 Mar 1813
10
Anna Davenport
[1.1.1.1.1.2.2.1.5.1]
b. 8 Sep 1765 d. 1 Aug 1842
William Torrey
b. 23 Nov 1754 d. 16 Sep 1817
11
Samuel Davenport Torrey
[1.1.1.1.1.2.2.1.5.1.1]
b. 14 Apr 1789 d. 23 Dec 1877
Susan Holman Waters
b. 4 Apr 1803 d. 3 Feb 1866
12
Delia Chapin Torrey
[1.1.1.1.1.2.2.1.5.1.1.1]
b. 30 Sep 1825 d. 23 Feb 1919
12
Louisa Maria Torrey
[1.1.1.1.1.2.2.1.5.1.1.2]
b. 11 Sep 1827 d. 8 Dec 1907 [
=>
]
12
Samuel Davenport Torrey
[1.1.1.1.1.2.2.1.5.1.1.3]
b. 10 Jan 1830 d. Aug 1830
12
Susan Waters Torrey
[1.1.1.1.1.2.2.1.5.1.1.4]
b. 26 Aug 1835 d. 1 Feb 1904 [
=>
]
12
Anna Davenport Torrey
[1.1.1.1.1.2.2.1.5.1.1.5]
b. 1 Nov 1840 d. 23 Jun 1900 [
=>
]
11
Joseph Torrey
[1.1.1.1.1.2.2.1.5.1.2]
b. 4 Oct 1790 d. 15 Nov 1836
Deborah Tuttle
b. 1795 d. 25 Jan 1844
12
Joseph Vinton Torrey
[1.1.1.1.1.2.2.1.5.1.2.1]
b. 4 Jan 1828
12
Eliza Ann Torrey
[1.1.1.1.1.2.2.1.5.1.2.2]
b. 12 Jan 1829
11
Louisa Torrey
[1.1.1.1.1.2.2.1.5.1.3]
b. 29 Mar 1792 d. 10 Jul 1874
11
Benjamin Torrey
[1.1.1.1.1.2.2.1.5.1.4]
b. 5 Mar 1794 d. 20 Oct 1797
11
Stephen Torrey
[1.1.1.1.1.2.2.1.5.1.5]
b. 25 Mar 1796 d. 29 Apr 1875
11
Benjamin Davenport Torrey
[1.1.1.1.1.2.2.1.5.1.6]
b. 19 Dec 1803 d. 24 Jun 1826
11
George Washington Torrey
[1.1.1.1.1.2.2.1.5.1.7]
b. 26 Oct 1806 d. 3 Oct 1885
Sabra Brown
b. 1807 d. 15 Jul 1889
12
Caroline Augusta Torrey
[1.1.1.1.1.2.2.1.5.1.7.1]
b. 5 Dec 1841 d. 22 Aug 1915 [
=>
]
12
George Washington Torrey
[1.1.1.1.1.2.2.1.5.1.7.2]
b. 7 Mar 1844 d. 29 Jul 1903
12
Annie Davenport Torrey
[1.1.1.1.1.2.2.1.5.1.7.3]
b. Abt 1846 d. Bef 1929 [
=>
]
12
Harriet Oliver Torrey
[1.1.1.1.1.2.2.1.5.1.7.4]
b. 5 Oct 1849 d. 26 Nov 1850
12
William Torrey
[1.1.1.1.1.2.2.1.5.1.7.5]
b. 8 Dec 1851 d. 18 Dec 1881
12
Maria Torrey
[1.1.1.1.1.2.2.1.5.1.7.6]
b. 30 Jun 1854 d. 21 Jul 1855
12
Louise Torrey
[1.1.1.1.1.2.2.1.5.1.7.7]
b. 7 Aug 1856
12
Charles Torrey
[1.1.1.1.1.2.2.1.5.1.7.8]
b. 6 Jul 1859 [
=>
]
12
Eleanor Torrey
[1.1.1.1.1.2.2.1.5.1.7.9]
b. 13 Nov 1862 [
=>
]
+
Peter Holbrook
10
David Davenport
[1.1.1.1.1.2.2.1.5.2]
b. 17 Jan 1767
10
Mary Davenport
[1.1.1.1.1.2.2.1.5.3]
b. 30 Sep 1768
10
Rebecca Davenport
[1.1.1.1.1.2.2.1.5.4]
b. 9 Apr 1770 d. 15 May 1794
10
Samuel Daniels Davenport
[1.1.1.1.1.2.2.1.5.5]
b. 14 Oct 1772 d. 13 Feb 1802
10
Chloe Davenport
[1.1.1.1.1.2.2.1.5.6]
b. 23 Mar 1774 d. 5 Mar 1808
10
Seth Davenport
[1.1.1.1.1.2.2.1.5.7]
b. 13 Jan 1775 d. 22 Apr 1843
10
Benjamin Davenport
[1.1.1.1.1.2.2.1.5.8]
b. 10 Jul 1780 d. 14 Jul 1862
9
Matilda Daniels
[1.1.1.1.1.2.2.1.6]
b. 16 Sep 1747
John Gould
b. Abt 1758
10
Mary Gould
[1.1.1.1.1.2.2.1.6.1]
b. 1779 d. 27 May 1854
9
David Daniels
[1.1.1.1.1.2.2.1.7]
b. 10 Nov 1749 d. 30 Apr 1811
+
Olive Adams
b. 1 Jan 1755 d. 16 Sep 1832
9
Huldah Daniels
[1.1.1.1.1.2.2.1.8]
b. 6 Jan 1752 d. 26 Jun 1836
Silas Penniman
b. 20 Aug 1751 d. 12 May 1777
10
Scammell Penniman
[1.1.1.1.1.2.2.1.8.1]
b. 12 Oct 1772
10
Rhene Penniman
[1.1.1.1.1.2.2.1.8.2]
b. 27 Jan 1774
10
Amos Penniman
[1.1.1.1.1.2.2.1.8.3]
b. 9 Oct 1775
10
Silas Penniman
[1.1.1.1.1.2.2.1.8.4]
b. 12 Aug 1777 d. 1820
Henry Dearth
b. 6 Jun 1741 d. 24 Jun 1804
10
Ruth Dearth
[1.1.1.1.1.2.2.1.8.5]
b. 13 Jul 1787
10
Irene Dearth
[1.1.1.1.1.2.2.1.8.6]
b. 7 Apr 1789
10
June Dearth
[1.1.1.1.1.2.2.1.8.7]
b. 7 Apr 1789
10
Leonard Dearth
[1.1.1.1.1.2.2.1.8.8]
b. 30 Oct 1791 d. 3 Feb 1880
10
Mercy Dearth
[1.1.1.1.1.2.2.1.8.9]
b. 10 Sep 1793
9
Moses Daniels
[1.1.1.1.1.2.2.1.9]
b. 25 Feb 1753
Abigail Aldrich
b. 25 Feb 1761 d. 5 Jul 1834
10
Cyrena Daniels
[1.1.1.1.1.2.2.1.9.1]
b. 26 Sep 1782
10
Salley Daniels
[1.1.1.1.1.2.2.1.9.2]
b. 27 Nov 1784 d. 6 Sep 1842
10
Abigail Daniels
[1.1.1.1.1.2.2.1.9.3]
b. 15 Nov 1786
10
Elbridge C Daniels
[1.1.1.1.1.2.2.1.9.4]
b. 28 Nov 1788
10
Kelly Daniels
[1.1.1.1.1.2.2.1.9.5]
b. 23 Sep 1791 d. 30 Dec 1839
9
Clotilda Daniels
[1.1.1.1.1.2.2.1.10]
b. 19 Sep 1755 d. Abt 1813
Sherebiah Baker
b. 18 Mar 1747 d. May 1823
10
Marshal Baker
[1.1.1.1.1.2.2.1.10.1]
b. 8 Nov 1774 d. 20 Oct 1848
10
Phila Baker
[1.1.1.1.1.2.2.1.10.2]
b. 10 Jul 1773
10
Marshall Baker
[1.1.1.1.1.2.2.1.10.3]
b. 1779
8
Priscilla Taft
[1.1.1.1.1.2.2.2]
b. 15 Aug 1721 d. Jan 1760
Moses Wood
b. 3 Apr 1712 d. Apr 1780
9
Mary Wood
[1.1.1.1.1.2.2.2.1]
b. 3 Mar 1740 d. 17 Apr 1841
9
Prissella Wood
[1.1.1.1.1.2.2.2.2]
b. 18 May 1741 d. 18 May 1741
9
Jerusha Wood
[1.1.1.1.1.2.2.2.3]
b. Abt 1744 d. 27 Apr 1790
9
Rachel Wood
[1.1.1.1.1.2.2.2.4]
b. 9 Jun 1746
9
Moses Wood
[1.1.1.1.1.2.2.2.5]
b. Abt 1748
9
Susanna Wood
[1.1.1.1.1.2.2.2.6]
b. Abt 1748
9
Daniel Wood
[1.1.1.1.1.2.2.2.7]
b. 10 Mar 1757
9
Hezekiah Wood
[1.1.1.1.1.2.2.2.8]
b. 14 Jan 1760 d. 26 May 1811
9
Rhoda Wood
[1.1.1.1.1.2.2.2.9]
b. 13 Apr 1762
8
Israel Taft
[1.1.1.1.1.2.2.3]
b. 23 Apr 1723 d. 1775
Martha Smith
b. 1722
9
Israel Taft
[1.1.1.1.1.2.2.3.1]
b. 12 Dec 1743
9
Amariah Taft
[1.1.1.1.1.2.2.3.2]
b. 18 Apr 1746 d. 1770
9
Oliver Taft
[1.1.1.1.1.2.2.3.3]
b. 4 Feb 1750
9
Elizabeth Taft
[1.1.1.1.1.2.2.3.4]
b. 27 Jul 1753
9
Marce Taft
[1.1.1.1.1.2.2.3.5]
b. 16 Jan 1757
8
Jacob Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4]
b. 22 Apr 1725 d. 15 Mar 1802
Esther Marsh
b. 28 Jun 1726 d. 14 Mar 1802
9
Esther Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.1]
b. 9 Jan 1747 d. 3 Feb 1834
James Taft
b. 9 Apr 1738 d. 14 Jan 1826
10
Lucy Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.1]
b. 22 Nov 1769 d. 29 Jul 1845
Ebenezer Winslow
b. 21 Jan 1772 d. 21 Feb 1841
11
Albert Winslow
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.1.1]
b. 24 Jul 1797
Sarah Gardner
b. 25 Jul 1803 d. 23 Sep 1840
12
Martha Maria Winslow
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.1.1.1]
b. 12 Mar 1826 d. 16 Mar 1842
12
Preston Willard Winslow
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.1.1.2]
b. 13 Nov 1828 [
=>
]
12
Mary Augusta Allen Winslow
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.1.1.3]
b. 14 Sep 1831
12
John Alvin Winslow
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.1.1.4]
b. 3 Jul 1834
12
Jasper Ross Winslow
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.1.1.5]
b. 7 Apr 1837 d. 25 Oct 1841
12
Sarah Adaline Winslow
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.1.1.6]
b. 20 Dec 1839 d. 9 Dec 1841
Sylvia Babbit
b. 27 Jan 1814
12
Jasper Albert Winslow
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.1.1.7]
b. 15 Apr 1842 d. 14 Oct 1864
11
Claramond Winslow
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.1.2]
b. 10 Feb 1799 d. 27 Apr 1834
John Hathaway
b. 22 May 1797
12
Son Hathaway
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.1.2.1]
b. Apr 1828 d. 14 Apr 1828
12
Francis Ebenezer Hathaway
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.1.2.2]
b. 9 Mar 1829 [
=>
]
12
Catherine Elizabeth Hathaway
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.1.2.3]
b. 18 Feb 1833
12
George H Hathaway
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.1.2.4]
b. 13 Aug 1839 [
=>
]
11
Alvin Winslow
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.1.3]
b. 27 Aug 1802 d. 9 Oct 1803
11
Paulina Maria Winslow
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.1.4]
b. 27 May 1805
+
Austin Crosby
b. 10 Mar 1805 d. 13 Jun 1868
11
Lucy Emma Winslow
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.1.5]
b. 17 Feb 1808 d. 20 Feb 1870
+
Matthew Henry McClary
b. 10 Mar 1801
10
Zilpha Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.2]
b. 1 Jul 1772 d. 24 Feb 1848
Nathan Fisher
b. 25 Jun 1770 d. 21 Mar 1847
11
Elias Fisher
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.2.1]
b. 10 Jul 1796
11
Elise Fisher
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.2.2]
b. 10 Jul 1796
11
Josiah Fisher
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.2.3]
b. 26 Feb 1798 d. 11 Apr 1799
11
Josiah Fisher
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.2.4]
b. 1 Dec 1801
11
Rachel Adaline Fisher
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.2.5]
b. 29 Jan 1804
+
Moses Daniels Southwick
11
Mary Caroline Fisher
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.2.6]
b. 22 Mar 1806
11
Nathan Fisher
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.2.7]
b. 21 Mar 1811
10
Irena Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.3]
b. 25 Oct 1774 d. 29 May 1790
10
Ezekial Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.4]
b. 21 Jan 1777 d. 24 Apr 1841
+
Olive Thayer
b. 10 Aug 1782 d. 1865
10
James Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.5]
b. 13 Jun 1780
10
Luke Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.6]
b. 3 Jun 1783
Nancy Wood
b. 6 Feb 1787 d. 6 May 1859
11
Clarissa Wood Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.6.1]
b. 3 May 1810 d. 1889
Caleb Chapin
b. 6 Feb 1806 d. 27 Sep 1883
12
Eunice Chapin
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.6.1.1]
b. 1 May 1832 d. 29 Sep 1920 [
=>
]
12
Ezra Wood Chapin
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.6.1.2]
b. 7 Jun 1836 d. 31 Mar 1909 [
=>
]
12
Edwin Chapin
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.6.1.3]
b. 7 Jun 1836 d. 27 Sep 1836
11
Moses Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.6.2]
b. 26 Jan 1812
Sylvia Ann Wheelock
b. 3 Feb 1815 d. 3 Oct 1855
12
Sarah Wood Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.6.2.1]
b. 6 Jan 1838 [
=>
]
12
Susan Hortense Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.6.2.2]
b. 5 Jan 1843
12
Luke Herbert Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.6.2.3]
b. 9 Nov 1846
11
Sarah Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.6.3]
b. 15 Jan 1815 d. 24 Dec 1898
Amariah Albee Wood
b. 2 Nov 1802 d. 14 Jun 1871
12
Sarah A Wood
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.6.3.1]
b. May 1837 d. 26 Sep 1837
12
Samuel Taft Wood
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.6.3.2]
b. 4 Oct 1841 d. Jun 1925 [
=>
]
12
Mary Baylies Wood
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.6.3.3]
b. 29 Apr 1847 d. 9 Sep 1847
12
Anna I Wood
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.6.3.4]
b. 18 Aug 1848 d. 1919
11
Irene Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.6.4]
b. 19 Sep 1816 d. 26 Jan 1900
Silas Mandeville Wheelock
b. 11 Nov 1817 d. 18 Oct 1901
12
Ellen Maria Wheelock
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.6.4.1]
b. 2 Sep 1842 d. 1871
12
Eugene Augustus Wheelock
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.6.4.2]
b. 15 Feb 1846 d. 14 Sep 1912 [
=>
]
12
Alice Augusta Wheelock
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.6.4.3]
b. 22 Jan 1849 d. Sep 1891
12
Arthur Wheelock
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.6.4.4]
b. 26 Mar 1851 d. 23 Sep 1927 [
=>
]
12
Henry Wheelock
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.6.4.5]
b. 14 Jan 1857 d. 13 Nov 1881
11
Chloe M Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.6.5]
b. 5 Feb 1823
Luke Southwick Farnham
b. 20 Jan 1817 d. 23 Aug 1883
12
Elizabeth Southwick Farnham
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.6.5.1]
b. 1852
12
Ella Frances Farnham
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.6.5.2]
b. 1855
12
Moses Taft Farnham
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.6.5.3]
b. 1858
12
Walter James Farnham
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.6.5.4]
b. 1862
11
James Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.6.6]
b. 1830
10
Esther Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.7]
b. 5 Aug 1786 d. 10 Aug 1858
Fuller Murdock
b. 17 Feb 1781 d. 8 Nov 1857
11
Philena Murdock
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.7.1]
b. 26 Aug 1807 d. 30 Jun 1835
Samuel Merriam
b. Abt 1803
12
George Nison Merriam
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.7.1.1]
b. 26 Dec 1834 d. 19 Nov 1903 [
=>
]
11
Abba Eliza Murdock
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.7.2]
b. 13 Nov 1808 d. 4 Apr 1834
Pemberton Brown
b. 11 Oct 1801 d. 30 Mar 1870
12
Tarissa Gregory Brown
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.7.2.1]
b. 3 Oct 1828 d. 12 Oct 1914 [
=>
]
12
Josephine Brown
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.7.2.2]
b. 29 Jan 1830 d. 16 Jan 1895 [
=>
]
12
Adin Ballou Brown
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.7.2.3]
b. 14 Nov 1831 d. 19 Apr 1880
12
Edin Ballow Brown
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.7.2.4]
b. 14 Nov 1831
12
Abba Eliza Brown
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.7.2.5]
b. 30 Jun 1833 d. 19 Oct 1914 [
=>
]
11
Moses Taft Murdock
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.7.3]
b. 12 Sep 1810 d. 7 Feb 1883
Dorinda Wood Grout
b. 19 Aug 1810 d. 15 Jan 1888
12
Cyrus Grout Murdock
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.7.3.1]
b. 16 Jun 1833 d. 7 Jun 1913 [
=>
]
12
Lewis Henry Murdock
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.7.3.2]
b. 17 Mar 1835 d. 25 Mar 1916 [
=>
]
12
Sarah A Murdock
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.7.3.3]
b. Jul 1837 d. 1 Sep 1838
12
Lucius Walter Murdock
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.7.3.4]
b. 11 Apr 1846 d. 1 Jul 1867
12
Samuel Justin Murdock
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.7.3.5]
b. 13 May 1848 d. 11 May 1910 [
=>
]
12
Lyman Wood Murdock
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.7.3.6]
b. 26 Dec 1853 d. Bef 1900 [
=>
]
11
John Murdock
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.7.4]
b. 9 Sep 1812 d. 13 Sep 1837
11
Charles Murdock
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.7.5]
b. 11 Feb 1815 d. 6 Aug 1869
Mary Ann Weightman
b. 3 Apr 1823 d. 11 May 1895
12
Charles W Murdock
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.7.5.1]
b. 4 Mar 1854 d. 5 Mar 1916 [
=>
]
11
Caleb Murdock
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.7.6]
b. 16 Feb 1817 d. 10 May 1892
Maria Howard Emerson
b. 27 Dec 1830 d. 11 Oct 1901
12
Frank Fuller Murdock
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.7.6.1]
b. 18 May 1857 d. 13 Jan 1939 [
=>
]
12
Herbert Emerson Murdock
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.7.6.2]
b. 16 Jan 1859 d. 18 Jan 1931 [
=>
]
12
Eugene Clifford Murdock
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.7.6.3]
b. 24 Nov 1863 d. 13 Sep 1924
12
Carrie Maria Murdock
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.7.6.4]
b. 4 Sep 1865 [
=>
]
11
George Taft Murdock
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.7.7]
b. 18 Mar 1819
Abbie Ann Robinson
b. Abt 1825
12
George Thurston Murdock
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.7.7.1]
b. 4 Jul 1846 d. 30 Jan 1933 [
=>
]
12
Lizzie Green Murdock
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.7.7.2]
b. 2 Sep 1857 d. 3 May 1879 [
=>
]
11
Harriet E. Murdock
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.7.8]
b. 6 Feb 1821 d. 30 Nov 1904
David Franum Wood
b. 16 Feb 1818 d. 4 Feb 1896
12
Arthur Eugene Wood
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.7.8.1]
b. 20 Jan 1844 d. 20 Apr 1920 [
=>
]
12
Hattie Esther Wood
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.7.8.2]
b. 5 Aug 1855 [
=>
]
11
Chapin Murdock
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.7.9]
b. 20 Jun 1823 d. 17 Sep 1882
Julia A Smith
b. 1824 d. 21 Jun 1909
12
Luther Oscar Murdock
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.7.9.1]
b. 6 Oct 1848 d. 1 Nov 1904 [
=>
]
12
Loren Nelson Murdock
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.7.9.2]
b. 3 Jul 1850 d. 11 May 1923 [
=>
]
12
Eldoras Filasker Murdock
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.7.9.3]
b. 18 Jun 1852 [
=>
]
12
William Fuller Murdock
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.7.9.4]
b. 19 Jun 1855 d. 26 Nov 1924 [
=>
]
12
Emma E Murdock
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.7.9.5]
b. 30 May 1857 d. 23 Jul 1913 [
=>
]
11
Mary Ann Murdock
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.7.10]
b. 18 Jun 1825 d. 27 Aug 1834
10
Moses Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.8]
b. 14 Jul 1788 d. 26 Jun 1810
10
Abigail Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.9]
b. 24 Jan 1791 d. 15 May 1837
Chandler Taft
b. 29 May 1792
11
Augustine Calvin Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.9.1]
b. 11 May 1817
Deborah Millett Taylor
12
Alice Bradford Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.9.1.1]
b. 26 Oct 1841
12
Edward A Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.1.9.1.2]
b. 8 Apr 1845
9
Timothy Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.2]
b. 3 Apr 1750 d. 30 Nov 1808
Priscilla Taft
b. 30 Apr 1749 d. 12 Sep 1833
10
Marcy Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.2.1]
b. 28 Sep 1771 d. 1 Aug 1848
+
Ezekiah Preston
b. Abt 1771
10
Josiah Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.2.2]
b. 3 May 1774
10
Abigail Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.2.3]
b. 14 Jan 1777 d. 17 Dec 1832
Moses Stone
b. 2 Mar 1775 d. 10 May 1803
11
Jonas Stone
[1.1.1.1.1.2.2.4.2.3.1]
b. 6 Jun 1795 d. 30 Sep 1795
11
Sukey Stone
[1.1.1.1.1.2.2.4.2.3.2]
b. 19 Feb 1798
10
Polly Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.2.4]
b. 1779 d. 5 Sep 1785
10
Timothy Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.2.5]
b. 1782 d. 5 Jan 1818
Mary "Polly" Reidel
b. 8 Feb 1784 d. 8 Feb 1863
11
Timothy Clark Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.2.5.1]
b. 21 Jul 1800 d. 11 May 1872
Mary A Hitchcock
b. 4 Jan 1802 d. 26 Oct 1842
12
Samuel Adams Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.2.5.1.1]
b. 11 Mar 1830 d. 5 Feb 1916 [
=>
]
12
Elizabeth C Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.2.5.1.2]
b. 6 Jun 1834 d. 13 Dec 1915 [
=>
]
11
Adolphus Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.2.5.2]
b. Abt 1804
11
Harry Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.2.5.3]
b. Abt 1806
11
Ezekiel Preston Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.2.5.4]
b. Abt 1807
11
Washington Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.2.5.5]
b. Abt 1808 d. Abt 1823
11
Charlotte Clark Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.2.5.6]
b. Abt 1810
+
Hyman Sage
b. Abt 1810
11
Christine Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.2.5.7]
b. 1811 d. 8 Jul 1847
+
George Heath
b. Abt 1811
11
Jacob R Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.2.5.8]
b. 29 Oct 1814 d. 1 Jan 1875
+
Caroline Cowles
b. 10 Jun 1817 d. 25 Jun 1875
10
Joseph Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.2.6]
b. 1784
10
Jonas Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.2.7]
b. 1786
10
Polly Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.2.8]
b. 1788 d. 1859
9
Jacob Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.3]
b. 1 Dec 1751 d. 30 May 1823
Mary Taft
b. 14 Feb 1753 d. 19 Jul 1832
10
Lois Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.3.1]
b. 27 Aug 1780 d. 27 Apr 1854
Josiah Seagrave
b. 14 Oct 1773 d. 20 Mar 1855
11
Mary Ann Seagrave
[1.1.1.1.1.2.2.4.3.1.1]
b. 17 Nov 1799 d. 10 Feb 1825
11
Jacob Taft Seagraves
[1.1.1.1.1.2.2.4.3.1.2]
b. 8 Apr 1802 d. 24 Sep 1870
11
Henrietta Frost Seagrave
[1.1.1.1.1.2.2.4.3.1.3]
b. 1 Dec 1803 d. 1 Jun 1823
11
Waity Grant Seagrave
[1.1.1.1.1.2.2.4.3.1.4]
b. 23 Sep 1805 d. 27 Jan 1859
11
Edward Seagrave
[1.1.1.1.1.2.2.4.3.1.5]
b. 3 Sep 1807 d. 15 Feb 1873
11
Lois Taft Seagrave
[1.1.1.1.1.2.2.4.3.1.6]
b. 13 Apr 1809 d. 19 Mar 1853
11
Josiah Seagrave, Jr
[1.1.1.1.1.2.2.4.3.1.7]
b. 24 May 1811 d. 21 Jul 1861
11
Malvina Seagrave
[1.1.1.1.1.2.2.4.3.1.8]
b. 2 Apr 1813 d. 16 Dec 1823
11
Caleb Seagrave
[1.1.1.1.1.2.2.4.3.1.9]
b. 8 Feb 1815 d. 14 Nov 1823
11
Son Seagrave
[1.1.1.1.1.2.2.4.3.1.10]
b. 3 May 1817 d. 3 May 1817
11
Daughter Seagrave
[1.1.1.1.1.2.2.4.3.1.11]
b. 3 May 1817 d. 3 May 1817
11
Esborn Seagrave
[1.1.1.1.1.2.2.4.3.1.12]
b. 28 Dec 1818 d. 27 Oct 1856
11
George Augustus Seagrave
[1.1.1.1.1.2.2.4.3.1.13]
b. 6 Jan 1823 d. 15 Nov 1884
10
Hannah Margaret Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.3.2]
b. 28 Nov 1782 d. 2 Apr 1857
Stephen Carpenter
b. 13 Aug 1778 d. 1 Oct 1854
11
Eunice Carpenter
[1.1.1.1.1.2.2.4.3.2.1]
b. Sep 1802 d. Mar 1864
11
Orsmus T Carpenter
[1.1.1.1.1.2.2.4.3.2.2]
b. Jan 1805 d. 4 Apr 1863
11
Joseph Rawson Carpenter
[1.1.1.1.1.2.2.4.3.2.3]
b. 2 Apr 1807 d. May 1839
11
Charlotte Taft Carpenter
[1.1.1.1.1.2.2.4.3.2.4]
b. 4 Feb 1809 d. 5 Sep 1845
11
Charles A Carpenter
[1.1.1.1.1.2.2.4.3.2.5]
b. 11 Feb 1813 d. 12 Aug 1887
11
Mary T Carpenter
[1.1.1.1.1.2.2.4.3.2.6]
b. 1815
11
Hannah Taft Carpenter
[1.1.1.1.1.2.2.4.3.2.7]
b. 20 Aug 1817 d. 17 Dec 1890
11
Nancy Carter Carpenter
[1.1.1.1.1.2.2.4.3.2.8]
b. 5 Jun 1820 d. 15 May 1898
11
Henrietta Carpenter
[1.1.1.1.1.2.2.4.3.2.9]
b. Apr 1823 d. Feb 1847
11
George Carpenter
[1.1.1.1.1.2.2.4.3.2.10]
b. 13 Jan 1825
10
Elisabeth Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.3.3]
b. 8 Nov 1784
Ephraim Taft
b. 18 Aug 1780
11
Mary Ann Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.3.3.1]
b. 22 May 1805
11
Ephriam Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.3.3.2]
b. 8 Feb 1807
10
Mary Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.3.4]
b. 16 Mar 1786 d. 25 Feb 1860
10
Charlotte Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.3.5]
b. 25 Feb 1789
10
John Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.3.6]
b. 3 Dec 1792 d. 29 May 1826
Lucretia Newell
b. 24 Sep 1795 d. 29 Dec 1863
11
Robert Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.3.6.1]
b. 27 May 1819
11
Jacob Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.3.6.2]
b. 19 May 1823
10
Orsmus Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.3.7]
b. 1 Jan 1795
9
Abigail Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.4]
b. 5 Oct 1754 d. 12 Aug 1775
Barzillai Taft
b. 3 Nov 1750 d. 21 Jan 1839
10
Eunice Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.4.1]
b. 28 Jan 1775 d. 30 May 1861
Phineas Chapin
b. 3 Aug 1769 d. 3 May 1839
11
Abby Chapin
[1.1.1.1.1.2.2.4.4.1.1]
b. 1 Feb 1796
11
Laurinda Chapin
[1.1.1.1.1.2.2.4.4.1.2]
b. 6 Feb 1798 d. 20 Dec 1866
11
Sarah Richardson Chapin
[1.1.1.1.1.2.2.4.4.1.3]
b. 30 Apr 1800 d. 16 Apr 1884
11
Chloe T Chapin
[1.1.1.1.1.2.2.4.4.1.4]
b. 8 Apr 1802 d. 5 Oct 1881
11
Mary Warren Chapin
[1.1.1.1.1.2.2.4.4.1.5]
b. 27 Feb 1804 d. 13 Nov 1890
11
Caleb Chapin
[1.1.1.1.1.2.2.4.4.1.6]
b. 6 Feb 1806 d. 27 Sep 1883
Clarissa Wood Taft
b. 3 May 1810 d. 1889
12
Eunice Chapin
[1.1.1.1.1.2.2.4.4.1.6.1]
b. 1 May 1832 d. 29 Sep 1920 [
=>
]
12
Ezra Wood Chapin
[1.1.1.1.1.2.2.4.4.1.6.2]
b. 7 Jun 1836 d. 31 Mar 1909 [
=>
]
12
Edwin Chapin
[1.1.1.1.1.2.2.4.4.1.6.3]
b. 7 Jun 1836 d. 27 Sep 1836
11
Margaret Ann Chapin
[1.1.1.1.1.2.2.4.4.1.7]
b. 16 Jun 1808 d. 15 Nov 1897
11
Bezaileel Taft Chapin
[1.1.1.1.1.2.2.4.4.1.8]
b. 21 Oct 1810 d. 28 May 1855
11
Samuel Judson Chapin
[1.1.1.1.1.2.2.4.4.1.9]
b. 27 Aug 1812 d. 18 Nov 1908
11
Son Chapin
[1.1.1.1.1.2.2.4.4.1.10]
b. 15 Oct 1815
11
Gardner Spring Chapin
[1.1.1.1.1.2.2.4.4.1.11]
b. 2 Oct 1817 d. 4 Aug 1892
11
Josiah Spring Chapin
[1.1.1.1.1.2.2.4.4.1.12]
b. 24 Aug 1820 d. 26 Dec 1882
9
Lois Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.5]
b. 28 Apr 1757 d. 10 Feb 1792
Caleb Farnum
b. 9 Nov 1753 d. 3 Jan 1829
10
Royal Farnham
[1.1.1.1.1.2.2.4.5.1]
b. 28 Nov 1775 d. 3 Sep 1845
+
Betsey Whitney
b. 29 Jul 1779
10
Easman Farnum
[1.1.1.1.1.2.2.4.5.2]
b. 22 Dec 1777
Rebecca Chamberlain
b. 10 Feb 1778
11
Almira Farnum
[1.1.1.1.1.2.2.4.5.2.1]
b. 1801 d. 24 Jan 1829
11
George V R Farnham
[1.1.1.1.1.2.2.4.5.2.2]
b. 12 Sep 1812 d. 3 Jul 1871
Nancy
b. 1815
12
Oscar W Farnham
[1.1.1.1.1.2.2.4.5.2.2.1]
b. 12 Nov 1835
10
Caleb Farnum
[1.1.1.1.1.2.2.4.5.3]
b. 15 Jul 1781 d. 16 Jun 1863
Silvania Allen
b. 5 Mar 1782 d. 13 Oct 1846
11
Elizabeth F Farnham
[1.1.1.1.1.2.2.4.5.3.1]
b. 21 Apr 1805 d. 20 Jul 1827
Mellen Garner Kempton
b. 20 Feb 1805 d. 4 Feb 1893
12
George Mellen Kempton
[1.1.1.1.1.2.2.4.5.3.1.1]
b. 13 Jun 1827 d. 29 Mar 1911
11
George A Farnham
[1.1.1.1.1.2.2.4.5.3.2]
b. 27 Jun 1807
+
Angeline Hanks
b. 1808 d. 1 Jan 1877
+
Sarah Taylor
b. Abt 1814
11
Clarissa Taft Farnum
[1.1.1.1.1.2.2.4.5.3.3]
b. 27 Jun 1807 d. 26 Oct 1839
+
Dugald Cameron Taylor
11
Edward Judson Farnham
[1.1.1.1.1.2.2.4.5.3.4]
b. 16 Mar 1809 d. 11 Jul 1894
Lucy G Goff
b. Abt 1809 d. 12 Oct 1876
12
Frances Farnham
[1.1.1.1.1.2.2.4.5.3.4.1]
b. 1830 d. 1857
12
Antoinette Farnham
[1.1.1.1.1.2.2.4.5.3.4.2]
b. Abt 1833
12
Louise Adelaide Farnum
[1.1.1.1.1.2.2.4.5.3.4.3]
b. Abt 1835
12
Sylvania Allen Farnham
[1.1.1.1.1.2.2.4.5.3.4.4]
b. 1836
12
Fanny Louisa Farnham
[1.1.1.1.1.2.2.4.5.3.4.5]
b. 1838
12
William Carlton Farnham
[1.1.1.1.1.2.2.4.5.3.4.6]
b. 1840
11
Caroline Farnum
[1.1.1.1.1.2.2.4.5.3.5]
b. 13 Aug 1810 d. 26 Aug 1810
11
Carleton Lee Farnham
[1.1.1.1.1.2.2.4.5.3.6]
b. 13 Jul 1811
Sarah Gaylord
b. Abt 1818 d. 23 Jul 1892
12
Edward G Farnum
[1.1.1.1.1.2.2.4.5.3.6.1]
b. 27 Jan 1840
12
Charles Caleb Farnum
[1.1.1.1.1.2.2.4.5.3.6.2]
b. 11 Sep 1841
12
Emily Adelaide Farnum
[1.1.1.1.1.2.2.4.5.3.6.3]
b. 21 Oct 1843 d. 24 Apr 1883
12
William Haddard Farnum
[1.1.1.1.1.2.2.4.5.3.6.4]
b. 27 Jan 1845 d. 22 Jan 1850
12
George Eugene Farnum
[1.1.1.1.1.2.2.4.5.3.6.5]
b. 9 Nov 1845 [
=>
]
12
William Stoddard Farnum
[1.1.1.1.1.2.2.4.5.3.6.6]
b. 27 Jan 1848 d. 22 Jan 1856
12
Clarence Asher Farnum
[1.1.1.1.1.2.2.4.5.3.6.7]
b. 7 Oct 1850
12
Mary Gaylord Farnum
[1.1.1.1.1.2.2.4.5.3.6.8]
b. 14 Jan 1854
11
William A Farnham
[1.1.1.1.1.2.2.4.5.3.7]
b. 13 Mar 1813 d. 28 Feb 1814
11
William A Farnham
[1.1.1.1.1.2.2.4.5.3.8]
b. 13 Aug 1815 d. 2 Aug 1860
+
Pheobe Adams
b. 1821
11
Dorcas Adelaide Farnum
[1.1.1.1.1.2.2.4.5.3.9]
b. 9 Jun 1820 d. 13 Aug 1842
11
Mary Frances Farnham
[1.1.1.1.1.2.2.4.5.3.10]
b. 29 Jul 1823 d. 1 Jan 1847
+
William Stoddard
+
Sally Jones
b. 1783 d. 12 May 1874
10
Clarissa Farnam
[1.1.1.1.1.2.2.4.5.4]
b. 22 Aug 1784
+
Elihu Morgan
b. 1780
9
Mercy Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.6]
b. 5 Mar 1758 d. 18 Feb 1843
Otis Russell
b. 9 Dec 1733
10
Meribah Russell
[1.1.1.1.1.2.2.4.6.1]
b. 1805 d. Aft 1860
9
Israel Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.7]
b. 1 Mar 1761 d. 24 Apr 1842
Submit Read
b. 21 Jun 1763 d. 17 May 1841
10
Ruth Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.7.1]
b. 5 Jan 1783
Benjamin Farrow
b. 9 Mar 1782 d. 17 Oct 1861
11
Drucilla Farrow
[1.1.1.1.1.2.2.4.7.1.1]
b. 10 Apr 1805 d. 7 Nov 1896
11
Theodore Grey Farrow
[1.1.1.1.1.2.2.4.7.1.2]
b. 25 Feb 1807 d. 23 Jan 1907
11
Submit Farrow
[1.1.1.1.1.2.2.4.7.1.3]
b. 4 Jan 1809 d. 22 Nov 1882
11
Cecelia Farrow
[1.1.1.1.1.2.2.4.7.1.4]
b. 26 May 1810 d. 18 Jul 1835
11
Israel Taft Farrow
[1.1.1.1.1.2.2.4.7.1.5]
b. 25 May 1812 d. 23 Apr 1903
11
Franklin Farrow
[1.1.1.1.1.2.2.4.7.1.6]
b. 31 Aug 1813 d. 3 Feb 1892
11
Independence Farrow
[1.1.1.1.1.2.2.4.7.1.7]
b. 4 Jul 1815 d. 7 Sep 1891
11
Constantine Farrow
[1.1.1.1.1.2.2.4.7.1.8]
b. 11 Mar 1817 d. 28 Feb 1871
11
Lucy Farrow
[1.1.1.1.1.2.2.4.7.1.9]
b. 13 Oct 1819 d. 12 Jul 1850
11
Benjamin Farrow
[1.1.1.1.1.2.2.4.7.1.10]
b. 13 Oct 1819 d. 17 Oct 1819
11
Caleb Walter Farrow
[1.1.1.1.1.2.2.4.7.1.11]
b. 16 Jan 1823 d. 26 Jul 1860
11
Emeline Farrow
[1.1.1.1.1.2.2.4.7.1.12]
b. 16 Jun 1824 d. 30 Aug 1842
11
Miranda Farrow
[1.1.1.1.1.2.2.4.7.1.13]
b. 5 Jul 1827 d. 2 Feb 1877
10
Clarisa Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.7.2]
b. 5 Mar 1786
10
Elzaphan Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.7.3]
b. 15 Feb 1788 d. 23 Mar 1847
Elisabeth Fowler
b. 1791 d. 30 Sep 1871
11
Gilbert Chase Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.7.3.1]
b. 22 Nov 1813
11
Emila Angenett Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.7.3.2]
b. 15 Sep 1815
11
Samuel Read Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.7.3.3]
b. 6 Aug 1818 d. 30 Aug 1835
11
John E Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.7.3.4]
b. 25 Feb 1821
11
Cyrus Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.7.3.5]
b. 27 Nov 1824 d. 6 Feb 1832
11
Lucinda M Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.7.3.6]
b. 26 Jul 1827
11
Elizabeth G. Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.7.3.7]
b. 17 May 1833
10
Abigail Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.7.4]
b. 9 Feb 1790 d. 5 Jun 1791
10
Laurana Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.7.5]
b. 13 May 1792
Cheany Taft
b. 8 Dec 1787 d. 13 Feb 1840
11
Caleb Walter Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.7.5.1]
b. 11 Oct 1813 d. 19 Dec 1813
11
Henry Cheney Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.7.5.2]
b. 20 Apr 1815
10
Lydia Mariah Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.7.6]
b. 10 Jul 1794
Washington White
b. 17 May 1796
11
Ruth Taft White
[1.1.1.1.1.2.2.4.7.6.1]
b. 16 Jun 1819
11
Sarah Ann White
[1.1.1.1.1.2.2.4.7.6.2]
b. 17 Sep 1821
11
Lurana Taft White
[1.1.1.1.1.2.2.4.7.6.3]
b. 14 Apr 1823
11
Lydia Mariah White
[1.1.1.1.1.2.2.4.7.6.4]
b. 3 Apr 1825
11
Eunice Fletcher White
[1.1.1.1.1.2.2.4.7.6.5]
b. 1 Jan 1827
11
Mary Elizabeth White
[1.1.1.1.1.2.2.4.7.6.6]
b. 15 Sep 1829
11
Margaret B White
[1.1.1.1.1.2.2.4.7.6.7]
b. 20 Jul 1833
11
Caroline Frances White
[1.1.1.1.1.2.2.4.7.6.8]
b. 20 Jan 1835
11
Henry Kirk White
[1.1.1.1.1.2.2.4.7.6.9]
b. 10 May 1837
11
William Edwards White
[1.1.1.1.1.2.2.4.7.6.10]
b. 8 Mar 1839
11
Lucy B White
[1.1.1.1.1.2.2.4.7.6.11]
b. 16 Oct 1841
11
Emma Jane White
[1.1.1.1.1.2.2.4.7.6.12]
b. 18 Feb 1845
10
Cyrus Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.7.7]
b. 3 Feb 1797
Lucinda Morse
b. 1800 d. 25 Jul 1860
11
Gustavus Elzaphan Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.7.7.1]
b. 29 Aug 1829 d. 23 Jun 1888
11
Son Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.7.7.2]
b. 1831
11
Peter Morse Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.7.7.3]
b. 1833
11
Edmond M Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.7.7.4]
b. 1834 d. 25 Oct 1858
10
Louis Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.7.8]
b. 25 Apr 1801
9
Eastman Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.8]
b. 16 Jun 1763 d. 29 Apr 1829
Chloa Taft
b. 25 Nov 1763 d. 4 May 1783
10
Eastman Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.1]
b. 2 May 1783 d. 8 Aug 1857
Hannah Taft
b. 1 Nov 1763 d. 3 Jul 1832
10
Chloe Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.2]
b. 7 Jul 1785 d. 25 Apr 1826
John Perry Benson
b. 22 Jul 1781 d. 21 Jan 1842
11
Charlotte Taft Benson
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.1]
b. 30 Sep 1807 d. 16 Jul 1878
Moses Dyer
b. 1803 d. Aft 1841
12
Merril B Dyer
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.1.1]
b. 2 Apr 1844 d. 2 Apr 1859
12
George Franklin Dyer
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.1.2]
b. 22 Jan 1846 d. 27 Feb 1917 [
=>
]
12
Chloe Allice Dyer
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.1.3]
b. 5 May 1848 d. 1932 [
=>
]
12
Angelne A Dyer
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.1.4]
b. 6 Sep 1852 [
=>
]
11
Ezra Taft Benson
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.2]
b. 22 Feb 1811 d. 3 Sep 1869
Pamelia Andrus
b. 21 Oct 1809 d. 14 Sep 1877
12
Charles Agustus Benson
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.2.1]
b. 26 Sep 1832 d. 14 Oct 1833
12
Chloe Jane Benson
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.2.2]
b. 1835 d. 1835
12
Charles Augustus Benson
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.2.3]
b. 9 Jul 1837 d. 18 Feb 1873
12
Jonathan Parsons Benson
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.2.4]
b. Mar 1841 d. Mar 1841
12
Adin Parsons Benson
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.2.5]
b. Mar 1841 d. Mar 1841
12
Pamelia Emma Benson
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.2.6]
b. 28 Feb 1842 d. 10 Feb 1892
12
Harvey Andrus Benson
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.2.7]
b. 26 Sep 1844 d. 26 Sep 1844
12
Isabella Benson
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.2.8]
b. 9 Mar 1846 d. 10 Feb 1922
12
Charlotte Taft Benson
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.2.9]
b. 4 Jul 1850 d. 30 Nov 1918 [
=>
]
Adeline Brooks Andrus
b. 18 Mar 1813 d. 20 Apr 1898
12
George Taft Benson
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.2.10]
b. 1 May 1846 d. 16 May 1919 [
=>
]
12
Florence Adeline Benson
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.2.11]
b. 17 Sep 1851 d. 25 Dec 1852
12
Nellie Benson
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.2.12]
b. 30 Nov 1851 d. 24 Jan 1885
12
Frank Andrus Benson
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.2.13]
b. 16 Oct 1853 d. 5 May 1937 [
=>
]
12
Samuel Benson
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.2.14]
b. 1853
Eliza Ann Perry
b. 30 Mar 1828 d. 30 Apr 1913
12
Alice Eliza Benson
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.2.15]
b. 11 Aug 1848 d. 3 Jun 1923
12
John Perry Benson
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.2.16]
b. 24 Sep 1849 d. 4 Jan 1921
12
Malina Adelaide Benson
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.2.17]
b. 21 Sep 1851 d. 31 Jul 1918
12
Orrin William Benson
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.2.18]
b. 4 Oct 1853 d. 17 May 1917
12
Carrie Stella Benson
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.2.19]
b. 22 May 1860 d. 15 Mar 1928
12
Abbie Della Benson
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.2.20]
b. 16 Oct 1862 d. 22 Oct 1925
12
Grace Ann Benson
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.2.21]
b. 31 Jan 1867 d. 15 Dec 1924
Elizabeth Gollaher
b. 30 Dec 1831 d. 4 May 1904
12
Fredrick Gollaher Benson
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.2.22]
b. 17 Jan 1855 d. 6 Jan 1915
12
Brigham Young Benson
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.2.23]
b. 17 Dec 1858 d. 11 Jul 1938
12
Luella Gollaher Benson
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.2.24]
b. 12 Nov 1860 d. 22 Jul 1881
12
William C Benson
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.2.25]
b. 11 Nov 1862 d. Sep 1937
12
Hyrum Smith Benson
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.2.26]
b. 3 May 1864 d. 4 May 1935
12
Edith Benson
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.2.27]
b. 22 Apr 1867 d. 11 Feb 1925
12
Lizzie Gollaher Benson
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.2.28]
b. 9 Jul 1869 d. 30 Jul 1946
Olive Mary Knight
b. 24 Jan 1830 d. 27 Mar 1905
12
Louisa Benson
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.2.29]
b. 29 Jun 1852 d. 29 Nov 1878
12
Heber Benson
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.2.30]
b. Abt 1860 d. Bef 1868
12
Moroni Benson
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.2.31]
b. 5 Nov 1861 d. 8 Jan 1934
12
Lorenzo Taft Benson
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.2.32]
b. 3 Aug 1863 d. 6 Nov 1950
12
Joseph Benson
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.2.33]
b. 13 Jul 1865 d. 5 Jun 1941
12
Ida May Benson
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.2.34]
b. 16 Apr 1867 d. 30 Jun 1929
12
Don Carlos Benson
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.2.35]
b. 29 Sep 1869 d. 19 Jan 1935
Mary Marie Larsen
b. 19 Dec 1843 d. 21 Feb 1926
12
Walter Taft Benson
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.2.36]
b. 17 Jun 1867 d. 6 Jun 1957
12
Henry Taft Benson
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.2.37]
b. 19 Mar 1869 d. 24 Feb 1947
+
Desdemona Wadsworth Fullmer
b. 6 Oct 1809 d. 9 Feb 1886
+
Lucinda Burton
b. 22 Oct 1825 d. 1 Oct 1863
11
George Taft Benson
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.3]
b. Abt 1813
Prudence Maria Gifford
b. Abt 1815
12
Walter Everet Benson
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.3.1]
b. 13 Sep 1857 d. 29 Apr 1907 [
=>
]
11
Hannah Benson
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.4]
b. 18 Sep 1816
Henry Dodge
b. 15 Dec 1812 d. 22 Jun 1883
12
John M Dodge
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.4.1]
b. 1838 d. 14 Feb 1898
12
Abbie R Dodge
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.4.2]
b. 1850 d. 27 Sep 1916 [
=>
]
11
Abbie Ann Benson
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.5]
b. Abt 1809 d. 21 Sep 1883
Calvin Rawson
b. 13 May 1797 d. 21 Jan 1868
12
Son Rawson
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.5.1]
b. Abt 1828 d. Abt 1838
11
John M Benson
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.2.6]
b. 1819 d. 12 Aug 1829
10
Ezra Taft
[1.1.1.1.1.2.2.4.8.3]
b. 6 Mar 1793 d. 19 Feb 1808
8
Hannah Taft
[1.1.1.1.1.2.2.5]
b. 16 Nov 1726 d. 15 Mar 1802
Elijah Clarke Benjamin
b. 8 Jun 1725 d. 1768
9
Elias Benjamin
[1.1.1.1.1.2.2.5.1]
b. 4 May 1750 d. 8 Apr 1823
Rhoda Paddock
b. 9 Sep 1785 d. 5 Jun 1858
10
Deborah Benjamin
[1.1.1.1.1.2.2.5.1.1]
b. 25 Apr 1803 d. 6 Dec 1871
10
Ezra H. Benjamin
[1.1.1.1.1.2.2.5.1.2]
b. 21 May 1804 d. 20 Jul 1876
10
Edmund Benjamin
[1.1.1.1.1.2.2.5.1.3]
b. 28 Jan 1806 d. 25 Nov 1887
10
Robert L Benjamin
[1.1.1.1.1.2.2.5.1.4]
b. 14 Jun 1808 d. 20 Jul 1892
10
Hannah Almedia Benjamin
[1.1.1.1.1.2.2.5.1.5]
b. 29 Sep 1810 d. Abt 1870
10
John Mills Benjamin
[1.1.1.1.1.2.2.5.1.6]
b. 5 Jun 1813 d. 1849
10
Isaac Paddock Benjamin
[1.1.1.1.1.2.2.5.1.7]
b. 21 Jul 1815 d. 5 Apr 1892
10
Mary E Benjamin
[1.1.1.1.1.2.2.5.1.8]
b. 1 Sep 1817 d. 3 Dec 1819
10
William F Benjamin
[1.1.1.1.1.2.2.5.1.9]
b. 18 Apr 1820 d. 10 Aug 1869
10
David E Benjamin
[1.1.1.1.1.2.2.5.1.10]
b. 1 May 1822 d. 25 Aug 1890
10
Mary Elizabeth Benjamin
[1.1.1.1.1.2.2.5.1.11]
b. 24 Jun 1824 d. 2 Oct 1894
10
Sidney S Benjamin
[1.1.1.1.1.2.2.5.1.12]
b. 19 Jul 1826 d. 7 May 1862
10
Jane Ann Benjamin
[1.1.1.1.1.2.2.5.1.13]
b. 7 Dec 1829 d. 29 Mar 1915
9
Chester Benjamin
[1.1.1.1.1.2.2.5.2]
b. 9 Feb 1751 d. 1830
9
William Benjamin
[1.1.1.1.1.2.2.5.3]
b. 6 Mar 1753
9
Captain Elijah Taft Benjamin
[1.1.1.1.1.2.2.5.4]
b. 27 Dec 1755 d. 17 Jun 1819
Elizabeth Paddock
b. 1 Nov 1762 d. 26 Apr 1822
10
Elias Paddock Benjamin
[1.1.1.1.1.2.2.5.4.1]
b. 6 May 1783 d. 27 Nov 1866
10
David Benjamin
[1.1.1.1.1.2.2.5.4.2]
b. 18 May 1785 d. 18 Feb 1825
10
Elijah E Benjamin
[1.1.1.1.1.2.2.5.4.3]
b. 26 Oct 1788 d. 19 May 1880
10
Charles Benjamin
[1.1.1.1.1.2.2.5.4.4]
b. 7 Oct 1789 d. 10 Feb 1874
10
Daughter Benjamin
[1.1.1.1.1.2.2.5.4.5]
b. 1791
10
Frederick B Benjamin
[1.1.1.1.1.2.2.5.4.6]
b. 1794 d. 1868
10
Aaron Benjamin
[1.1.1.1.1.2.2.5.4.7]
b. 1801 d. 4 Feb 1883
10
Loretta Benjamin
[1.1.1.1.1.2.2.5.4.8]
b. 5 Feb 1804 d. 8 Feb 1886
9
Cyrus Benjamin
[1.1.1.1.1.2.2.5.5]
b. 7 Jul 1762 d. 19 Jul 1817
Rhoda Maria Dibble
b. 7 Oct 1771 d. 8 Dec 1817
10
Mary Crosby Benjamin
[1.1.1.1.1.2.2.5.5.1]
b. 11 Oct 1790
10
Hannah Benjamin
[1.1.1.1.1.2.2.5.5.2]
b. 2 Jan 1792 d. 1 Jan 1794
10
David C Benjamin
[1.1.1.1.1.2.2.5.5.3]
b. 7 Nov 1793
10
Anna Benjamin
[1.1.1.1.1.2.2.5.5.4]
b. 22 Jan 1796 d. 9 Oct 1817
10
Annis Benjamin
[1.1.1.1.1.2.2.5.5.5]
b. 10 Feb 1798 d. 16 Jun 1869
10
Peter Benjamin
[1.1.1.1.1.2.2.5.5.6]
b. 14 Feb 1800 d. 2 Sep 1839
10
Cyrus Benjamin
[1.1.1.1.1.2.2.5.5.7]
b. 11 Jul 1801
10
Nathaniel Benjamin
[1.1.1.1.1.2.2.5.5.8]
b. 23 Jun 1803
10
Charles J Benjamin
[1.1.1.1.1.2.2.5.5.9]
b. 17 Feb 1805 d. 1877
10
Elijah Benjamin
[1.1.1.1.1.2.2.5.5.10]
b. 28 May 1807
10
Eliza "Wealthy" Benjamin
[1.1.1.1.1.2.2.5.5.11]
b. 28 May 1807 d. 28 Jan 1862
10
Joel Samuel Benjamin
[1.1.1.1.1.2.2.5.5.12]
b. 17 Apr 1809 d. 4 Feb 1882
10
Catherine E Benjamin
[1.1.1.1.1.2.2.5.5.13]
b. 18 Jan 1814
10
Cyrus S Benjamin
[1.1.1.1.1.2.2.5.5.14]
b. 13 Jun 1816
10
Daniel W Benjamin
[1.1.1.1.1.2.2.5.5.15]
b. 13 Jun 1816 d. 2 Jun 1892
9
Hannah Benjamin
[1.1.1.1.1.2.2.5.6]
b. 7 Jul 1762 d. 13 May 1840
9
Mary Benjamin
[1.1.1.1.1.2.2.5.7]
b. 7 Jul 1768 d. 5 Feb 1849
9
Darius Benjamin
[1.1.1.1.1.2.2.5.8]
b. 17 Jan 1758 d. 12 Feb 1850
8
Elisha Taft
[1.1.1.1.1.2.2.6]
b. 3 May 1728 d. 3 Mar 1791
Experience Taft
b. 7 Apr 1733 d. 15 Mar 1817
9
Hannah Taft
[1.1.1.1.1.2.2.6.1]
b. 16 Mar 1758
9
Elisha Taft
[1.1.1.1.1.2.2.6.2]
b. 4 Mar 1761 d. 16 Jan 1820
Mary Sadler
b. 15 Aug 1768 d. 1800
10
Hiram Taft
[1.1.1.1.1.2.2.6.2.1]
b. 2 Apr 1789 d. 15 Nov 1794
10
Elisha Taft
[1.1.1.1.1.2.2.6.2.2]
b. 23 Jul 1791 d. 26 Feb 1858
10
Ormon Taft
[1.1.1.1.1.2.2.6.2.3]
b. 11 Nov 1793 d. 23 Jan 1794
10
Mary Taft
[1.1.1.1.1.2.2.6.2.4]
b. 23 May 1795 d. 23 Feb 1875
9
Sarah Taft
[1.1.1.1.1.2.2.6.3]
b. 21 Mar 1763 d. 11 Oct 1835
Ezra Wood, Jr
b. 12 Mar 1759 d. 10 May 1837
10
Ezra Wood
[1.1.1.1.1.2.2.6.3.1]
b. 25 Oct 1781
10
Experience Wood
[1.1.1.1.1.2.2.6.3.2]
b. 16 Mar 1783 d. 14 Oct 1818
10
Sarah Wood
[1.1.1.1.1.2.2.6.3.3]
b. 7 Aug 1784
10
Elisha Wood
[1.1.1.1.1.2.2.6.3.4]
b. 24 Apr 1786 d. 19 Oct 1797
10
Jonathan Wood
[1.1.1.1.1.2.2.6.3.5]
b. 8 Oct 1787 d. 26 Feb 1846
10
Anna Wood
[1.1.1.1.1.2.2.6.3.6]
b. 31 Aug 1789 d. 20 Mar 1832
10
Chapin Wood
[1.1.1.1.1.2.2.6.3.7]
b. 2 Apr 1792
10
Lucy Wood
[1.1.1.1.1.2.2.6.3.8]
b. 11 Nov 1794 d. 10 Dec 1826
10
Silva Wood
[1.1.1.1.1.2.2.6.3.9]
b. 29 Apr 1796
10
Silva Wood
[1.1.1.1.1.2.2.6.3.10]
b. 29 Apr 1796
10
Phila Wood
[1.1.1.1.1.2.2.6.3.11]
b. 5 Jul 1798
10
Elisha Wood
[1.1.1.1.1.2.2.6.3.12]
b. 7 Nov 1800
10
Simeon Wood
[1.1.1.1.1.2.2.6.3.13]
b. 5 Jan 1805
9
Israel Taft
[1.1.1.1.1.2.2.6.4]
b. 12 Feb 1766
9
Joseph Taft
[1.1.1.1.1.2.2.6.5]
b. 15 Sep 1768 d. Aft 29 Sep 1815
Sarah Farrar
b. 14 Sep 1764 d. 5 Aug 1810
10
Experience
[1.1.1.1.1.2.2.6.5.1]
b. 5 Feb 1792
10
Amiel F Taft
[1.1.1.1.1.2.2.6.5.2]
b. 1 Oct 1794 d. 29 Nov 1869
10
Roxalana Taft
[1.1.1.1.1.2.2.6.5.3]
b. 22 Jan 1798
10
Sofrona Taft
[1.1.1.1.1.2.2.6.5.4]
b. 17 Jun 1800
10
Esquire Taft
[1.1.1.1.1.2.2.6.5.5]
b. 28 Apr 1803 d. 11 Mar 1865
10
Deborah R Taft
[1.1.1.1.1.2.2.6.5.6]
b. 6 Jan 1806
+
Marcy Stockwell
b. Abt 1794
8
Mercy Taft
[1.1.1.1.1.2.2.7]
b. 7 Apr 1733 d. 27 Mar 1801
Benjamin Green
b. 11 Aug 1734 d. 16 Aug 1797
9
Benjamin Green
[1.1.1.1.1.2.2.7.1]
b. 6 Jan 1754
9
Israel Green
[1.1.1.1.1.2.2.7.2]
b. 22 Jun 1755
9
Margery Green
[1.1.1.1.1.2.2.7.3]
b. 1 Feb 1758 d. 22 Sep 1838
Josiah Taft
b. 28 Oct 1752 d. 8 Jan 1846
10
Josiah Taft
[1.1.1.1.1.2.2.7.3.1]
b. 10 Apr 1778 d. 30 Dec 1790
10
Lydia Taft
[1.1.1.1.1.2.2.7.3.2]
b. 13 Feb 1780
10
Israel Taft
[1.1.1.1.1.2.2.7.3.3]
b. 30 Jul 1782 d. 10 Apr 1840
Ann Taft
b. 23 Aug 1791 d. 17 Dec 1821
11
Julia Ann Taft
[1.1.1.1.1.2.2.7.3.3.1]
b. 15 Apr 1810
11
Marcy Taft
[1.1.1.1.1.2.2.7.3.3.2]
b. 2 Jun 1812
+
Freeland Stockwell
b. 19 Mar 1808 d. 17 Jun 1887
10
Benjamin Taft
[1.1.1.1.1.2.2.7.3.4]
b. 3 Aug 1784 d. 13 May 1863
10
Mercy Taft
[1.1.1.1.1.2.2.7.3.5]
b. 1786 d. 12 Jun 1803
10
Polly Taft
[1.1.1.1.1.2.2.7.3.6]
b. 23 Sep 1790
10
Andre Taft
[1.1.1.1.1.2.2.7.3.7]
b. 25 Jun 1792 d. 26 Jun 1850
Sarah Williams Baker
b. 8 Feb 1796
11
Margary Ann Taft
[1.1.1.1.1.2.2.7.3.7.1]
b. 4 May 1818 d. 4 Nov 1904
Charles W Hartwell
b. 1816 d. Bef 1904
12
Margery Hartwell
[1.1.1.1.1.2.2.7.3.7.1.1]
b. 30 Oct 1849
11
Caroline Taft
[1.1.1.1.1.2.2.7.3.7.2]
b. 21 Aug 1821 d. 7 Nov 1907
John Flint Smith
b. 7 Nov 1815
12
Mary Flint Smith
[1.1.1.1.1.2.2.7.3.7.2.1]
b. 31 Mar 1850 d. 21 Aug 1852
12
Effie Caroline Smith
[1.1.1.1.1.2.2.7.3.7.2.2]
b. 28 Nov 1857 d. Aft 1902
10
Judson Taft
[1.1.1.1.1.2.2.7.3.8]
b. 14 Feb 1793 d. 26 Jan 1891
10
Eunice Taft
[1.1.1.1.1.2.2.7.3.9]
b. 14 Mar 1795
10
Harry Taft
[1.1.1.1.1.2.2.7.3.10]
b. 5 Mar 1797
10
Guilford Hodges Taft
[1.1.1.1.1.2.2.7.3.11]
b. 1 Jan 1799 d. 22 Nov 1816
9
Marcy Green
[1.1.1.1.1.2.2.7.4]
b. 1 Jan 1760 d. 8 Jun 1815
Cummings Taft
b. 27 Aug 1770 d. 22 Jun 1841
10
Ezra Taft
[1.1.1.1.1.2.2.7.4.1]
b. 13 May 1797 d. 16 Nov 1878
Mercy G White
b. 1796 d. 14 Mar 1822
11
Austin Taft
[1.1.1.1.1.2.2.7.4.1.1]
b. 1 Mar 1822 d. 4 Sep 1844
Susanna Keith
b. 3 Jan 1801
11
Laura Ann M Taft
[1.1.1.1.1.2.2.7.4.1.2]
b. 26 Jun 1824 d. 26 May 1855
Oliver Taft
b. 6 Nov 1771 d. 20 Feb 1853
12
Laura Ann Maria Taft
[1.1.1.1.1.2.2.7.4.1.2.1]
b. 7 Jul 1844
12
Son Taft
[1.1.1.1.1.2.2.7.4.1.2.2]
b. 7 Jul 1844 d. 21 Jul 1844
12
Joseph K Taft
[1.1.1.1.1.2.2.7.4.1.2.3]
b. 25 Sep 1846 d. Jul 1868
12
Chloe Jane Taft
[1.1.1.1.1.2.2.7.4.1.2.4]
b. 25 Nov 1849
11
Lucinda M Taft
[1.1.1.1.1.2.2.7.4.1.3]
b. 15 Mar 1826 d. 5 Mar 1906
Charles White
b. 1825 d. 25 Mar 1899
12
Alice Maria White
[1.1.1.1.1.2.2.7.4.1.3.1]
b. 7 May 1865 d. 10 Dec 1892 [
=>
]
12
Walter Arnold White
[1.1.1.1.1.2.2.7.4.1.3.2]
b. 9 May 1869 [
=>
]
11
Artemas K Taft
[1.1.1.1.1.2.2.7.4.1.4]
b. 24 May 1828 d. 27 Dec 1878
Jane
b. 1827
12
Olive A Taft
[1.1.1.1.1.2.2.7.4.1.4.1]
b. Abt 1850
12
Albert Eugene Taft
[1.1.1.1.1.2.2.7.4.1.4.2]
b. 13 Aug 1852
12
Susan Ellen Taft
[1.1.1.1.1.2.2.7.4.1.4.3]
b. Abt 1859 [
=>
]
12
John Taft
[1.1.1.1.1.2.2.7.4.1.4.4]
b. 3 Jun 1864
12
Jane Taft
[1.1.1.1.1.2.2.7.4.1.4.5]
b. 3 Jun 1864
11
Uranah Taft
[1.1.1.1.1.2.2.7.4.1.5]
b. 25 Jan 1831
11
Daines C Taft
[1.1.1.1.1.2.2.7.4.1.6]
b. 1835
Olive Cleveland Smith
b. 16 Oct 1828 d. 15 Mar 1910
12
George Edward Taft
[1.1.1.1.1.2.2.7.4.1.6.1]
b. 7 Feb 1860 d. 10 Oct 1860
12
Celinda Grace Taft
[1.1.1.1.1.2.2.7.4.1.6.2]
b. 19 Aug 1861
12
Albert Smith Taft
[1.1.1.1.1.2.2.7.4.1.6.3]
b. 7 Feb 1867
11
Susan A Taft
[1.1.1.1.1.2.2.7.4.1.7]
b. 1838
11
Hannah Jane Taft
[1.1.1.1.1.2.2.7.4.1.8]
b. 17 Nov 1839 d. 7 Jan 1848
10
Benjamin Taft
[1.1.1.1.1.2.2.7.4.2]
b. 10 Aug 1798 d. 29 May 1799
10
Benjamin Taft
[1.1.1.1.1.2.2.7.4.3]
b. 6 May 1800 d. 17 Oct 1828
Martha Bethsheba White
b. 1803
11
Benjamin Lorin Taft
[1.1.1.1.1.2.2.7.4.3.1]
b. 25 Jun 1823
+
Paulina Wheelock
b. 27 Oct 1827
11
Russell White Taft
[1.1.1.1.1.2.2.7.4.3.2]
b. 23 Jan 1826 d. 4 Dec 1868
10
Hannah G Taft
[1.1.1.1.1.2.2.7.4.4]
b. 18 May 1802 d. 8 Jan 1843
Newell Taft
b. 28 Jul 1804 d. 4 Nov 1873
11
Albert Taft
[1.1.1.1.1.2.2.7.4.4.1]
b. 28 Aug 1823 d. Aft 1874
Sally L Bartlett
b. 14 Oct 1827 d. 1 Sep 1874
12
Charles B Taft
[1.1.1.1.1.2.2.7.4.4.1.1]
b. Feb 1854 d. 23 Sep 1854
12
Hannah L Taft
[1.1.1.1.1.2.2.7.4.4.1.2]
b. 5 Feb 1856
11
Marcy Taft
[1.1.1.1.1.2.2.7.4.4.2]
b. Mar 1829 d. 12 Apr 1830
11
Charles M Taft
[1.1.1.1.1.2.2.7.4.4.3]
b. Jan 1843 d. 7 Dec 1843
9
Hannah Green
[1.1.1.1.1.2.2.7.5]
b. 2 Apr 1763
9
Rachel Green
[1.1.1.1.1.2.2.7.6]
b. 27 Aug 1765
9
Samuel Green
[1.1.1.1.1.2.2.7.7]
b. 14 Mar 1767
8
Stephen Taft
[1.1.1.1.1.2.2.8]
b. 21 Aug 1734 d. 3 Feb 1803
Anna Taft
b. 14 Apr 1748 d. 3 Apr 1830
9
Lydia Taft
[1.1.1.1.1.2.2.8.1]
b. 13 Oct 1766 d. 13 Jan 1847
9
Hazeltine Taft
[1.1.1.1.1.2.2.8.2]
b. 6 Jan 1769 d. 18 Jul 1856
9
Gravenor Taft
[1.1.1.1.1.2.2.8.3]
b. 1773 d. 1838
9
Marcy Taft
[1.1.1.1.1.2.2.8.4]
b. 5 Sep 1775
9
Ephraim Taft
[1.1.1.1.1.2.2.8.5]
b. 18 Aug 1780
Elisabeth Taft
b. 8 Nov 1784
10
Mary Ann Taft
[1.1.1.1.1.2.2.8.5.1]
b. 22 May 1805
10
Ephriam Taft
[1.1.1.1.1.2.2.8.5.2]
b. 8 Feb 1807
9
Lovice Taft
[1.1.1.1.1.2.2.8.6]
b. 1 Jul 1783
9
Anna Taft
[1.1.1.1.1.2.2.8.7]
b. 29 Nov 1784
9
Stephen Taft
[1.1.1.1.1.2.2.8.8]
b. 12 Dec 1787
9
Adolphas Taft
[1.1.1.1.1.2.2.8.9]
b. 2 Oct 1791
8
Samuel Taft
[1.1.1.1.1.2.2.9]
b. 23 Sep 1735 d. 2 Aug 1816
Mary Murdock
b. 3 Jan 1742 d. 26 Mar 1785
9
Frederick Taft
[1.1.1.1.1.2.2.9.1]
b. 19 Jun 1759 d. 10 Feb 1846
Abigail Wood
b. 29 Aug 1761 d. 2 Jun 1851
10
Samuel Taft
[1.1.1.1.1.2.2.9.1.1]
b. 12 Dec 1782 d. 8 Feb 1842
10
Murdock Taft
[1.1.1.1.1.2.2.9.1.2]
b. 8 Dec 1784 d. 6 Aug 1820
10
Calista Taft
[1.1.1.1.1.2.2.9.1.3]
b. 31 Jan 1787 d. 11 Dec 1864
10
Clarinda Taft
[1.1.1.1.1.2.2.9.1.4]
b. 28 Feb 1789 d. 11 Apr 1877
Cabel Mowry
b. Abt 1783 d. 16 May 1845
11
Emily M Mowry
[1.1.1.1.1.2.2.9.1.4.1]
b. 13 Oct 1814 d. 25 May 1880
William Collins Boyden
b. 8 May 1811
12
Mary Amanda Boyden
[1.1.1.1.1.2.2.9.1.4.1.1]
b. 16 Aug 1834 [
=>
]
12
William Collins Boyden
[1.1.1.1.1.2.2.9.1.4.1.2]
b. 3 Apr 1836 d. 20 Mar 1882
12
Sanford H Boyden
[1.1.1.1.1.2.2.9.1.4.1.3]
b. 20 Dec 1838 d. 18 Sep 1869
12
Decatur M Boyden
[1.1.1.1.1.2.2.9.1.4.1.4]
b. 21 Aug 1840 d. Abt 1951 [
=>
]
12
Emily Frances Boyden
[1.1.1.1.1.2.2.9.1.4.1.5]
b. 19 Jan 1845 d. 17 Sep 1846
12
Emily Ann Boyden
[1.1.1.1.1.2.2.9.1.4.1.6]
b. 10 Jan 1848 d. Abt 1958
12
Reuben M Boyden
[1.1.1.1.1.2.2.9.1.4.1.7]
b. 19 Dec 1853 d. 5 Sep 1887
12
Amey Boyden
[1.1.1.1.1.2.2.9.1.4.1.8]
b. 23 May 1856 d. 30 Sep 1915
11
Decatur Mowrey
[1.1.1.1.1.2.2.9.1.4.2]
b. 30 Sep 1816 d. 31 Jul 1856
11
Bainbridge Mowry
[1.1.1.1.1.2.2.9.1.4.3]
b. 23 Jul 1818 d. 1893
11
Albert Mowry
[1.1.1.1.1.2.2.9.1.4.4]
b. 20 Apr 1822 d. 30 Mar 1900
11
Reuben Ransom Mowrey
[1.1.1.1.1.2.2.9.1.4.5]
b. 5 Apr 1826
11
Anna Ransom Mowry
[1.1.1.1.1.2.2.9.1.4.6]
b. 13 Sep 1827 d. 15 Jan 1903
11
Wesley Mowry
[1.1.1.1.1.2.2.9.1.4.7]
b. 26 May 1830 d. 11 Aug 1833
10
Frederic A Taft
[1.1.1.1.1.2.2.9.1.5]
b. 7 Apr 1790 d. 18 Sep 1837
10
Nabby Taft
[1.1.1.1.1.2.2.9.1.6]
b. 7 Jun 1793 d. 19 Jul 1880
10
Harriet Taft
[1.1.1.1.1.2.2.9.1.7]
b. 25 Jul 1795 d. 3 Sep 1852
10
Parla Parilla Taft
[1.1.1.1.1.2.2.9.1.8]
b. 5 Mar 1798 d. 26 Sep 1852
10
Ezra Wood Taft
[1.1.1.1.1.2.2.9.1.9]
b. 26 Aug 1800 d. 8 Feb 1885
10
Mary Ann Taft
[1.1.1.1.1.2.2.9.1.10]
b. 11 Sep 1803 d. 7 Sep 1850
10
Margaret Taft
[1.1.1.1.1.2.2.9.1.11]
b. 31 May 1806 d. 23 Jan 1891
9
Sibbel Taft
[1.1.1.1.1.2.2.9.2]
b. 19 Aug 1760 d. 28 Sep 1761
9
Lyman Taft
[1.1.1.1.1.2.2.9.3]
b. 14 Mar 1762 d. 24 Jul 1833
9
Mercy Taft
[1.1.1.1.1.2.2.9.4]
b. 23 Apr 1765 d. 25 Apr 1768
9
Willard Taft
[1.1.1.1.1.2.2.9.5]
b. 30 Oct 1766 d. 14 Sep 1845
9
Parley Taft
[1.1.1.1.1.2.2.9.6]
b. 20 Jan 1768 d. 13 Apr 1768
9
Merret Taft
[1.1.1.1.1.2.2.9.7]
b. 26 Jan 1769
9
Otis Taft
[1.1.1.1.1.2.2.9.8]
b. 29 Oct 1771
9
Farla Taft
[1.1.1.1.1.2.2.9.9]
b. 24 Mar 1774 d. 6 Apr 1864
9
Washington Taft
[1.1.1.1.1.2.2.9.10]
b. 16 Sep 1775
9
Philena Taft
[1.1.1.1.1.2.2.9.11]
b. 11 Mar 1781 d. 1814
9
George Washington Taft
[1.1.1.1.1.2.2.9.12]
b. 1 May 1783 d. 30 Nov 1824
Experiance Humes
b. 27 May 1750 d. 15 Jan 1837
9
Dandridge Taft
[1.1.1.1.1.2.2.9.13]
b. 1 Aug 1787 d. 10 Aug 1832
9
Warner Taft
[1.1.1.1.1.2.2.9.14]
b. 15 Sep 1789 d. 3 Aug 1837
9
Experiance Taft
[1.1.1.1.1.2.2.9.15]
b. 10 Jun 1791 d. 30 Nov 1863
9
Polley Taft
[1.1.1.1.1.2.2.9.16]
b. 18 Mar 1794
8
Margery Taft
[1.1.1.1.1.2.2.10]
b. 14 May 1738 d. 20 Jan 1813
Simeon Wood
b. 7 Jan 1732 d. 11 May 1802
9
Stephen Wood
[1.1.1.1.1.2.2.10.1]
b. 14 Oct 1761 d. Abt 1820
9
Simeon Wood, Jr
[1.1.1.1.1.2.2.10.2]
b. 14 Oct 1761 d. 1819
9
Rhoda Wood
[1.1.1.1.1.2.2.10.3]
b. 25 May 1763 d. 8 Apr 1832
9
Jerusha Wood
[1.1.1.1.1.2.2.10.4]
b. 28 Jun 1765 d. 8 Apr 1832
Asa Newell
b. 27 Nov 1761 d. 4 Aug 1808
10
Caleb Newell
[1.1.1.1.1.2.2.10.4.1]
b. Abt 1786
10
Eabon Carter Newell
[1.1.1.1.1.2.2.10.4.2]
b. 17 Nov 1788 d. 3 Mar 1831
10
Matilda Newell
[1.1.1.1.1.2.2.10.4.3]
b. 1793 d. 28 Aug 1830
10
Lucretia Newell
[1.1.1.1.1.2.2.10.4.4]
b. 24 Sep 1795 d. 29 Dec 1863
John Taft
b. 3 Dec 1792 d. 29 May 1826
11
Robert Taft
[1.1.1.1.1.2.2.10.4.4.1]
b. 27 May 1819
11
Jacob Taft
[1.1.1.1.1.2.2.10.4.4.2]
b. 19 May 1823
10
Jerusha Newell
[1.1.1.1.1.2.2.10.4.5]
b. 7 Nov 1799 d. 31 Oct 1879
10
Asa Newell
[1.1.1.1.1.2.2.10.4.6]
b. 31 Aug 1803 d. Apr 1865
9
Caleb Wood
[1.1.1.1.1.2.2.10.5]
b. 2 Jun 1767 d. 24 Jun 1769
9
Willis Wood
[1.1.1.1.1.2.2.10.6]
b. 14 Jul 1769 d. 5 Oct 1779
9
Nathaniel G Wood
[1.1.1.1.1.2.2.10.7]
b. 24 Jul 1771 d. 4 Sep 1847
9
Lois Wood
[1.1.1.1.1.2.2.10.8]
b. 8 Nov 1772 d. 20 Apr 1773
9
Eunice Wood
[1.1.1.1.1.2.2.10.9]
b. 11 Apr 1773 d. 28 Jun 1791
9
Jesse Wood
[1.1.1.1.1.2.2.10.10]
b. 29 Aug 1775 d. Bef 1884
9
Mary Wood
[1.1.1.1.1.2.2.10.11]
b. 3 Jan 1778 d. 3 Jan 1868
9
Sibel Wood
[1.1.1.1.1.2.2.10.12]
b. 12 Jan 1781 d. Feb 1831
8
Silas Taft
[1.1.1.1.1.2.2.11]
b. 17 Dec 1739 d. 10 May 1741
8
Rachel Taft
[1.1.1.1.1.2.2.12]
b. 18 Jul 1742 d. 30 Dec 1747
8
Silas Taft
[1.1.1.1.1.2.2.13]
b. 5 Nov 1744
Elizabeth Sadler
b. 13 Sep 1754
9
Stephen Taft
[1.1.1.1.1.2.2.13.1]
b. 22 Feb 1773 d. 26 Oct 1846
9
Silas Taft
[1.1.1.1.1.2.2.13.2]
b. 2 Jun 1775
9
Israel Taft
[1.1.1.1.1.2.2.13.3]
b. 22 Sep 1777 d. 19 May 1842
9
Joel Taft
[1.1.1.1.1.2.2.13.4]
b. 28 Apr 1780
9
Belzaleel Taft
[1.1.1.1.1.2.2.13.5]
b. 28 Jan 1783 d. 15 Apr 1831
9
Otis Taft
[1.1.1.1.1.2.2.13.6]
b. 17 Sep 1786 d. 19 Nov 1827
Thankful Benson
b. 29 Aug 1783 d. 11 Apr 1808
10
Tilus Vespasian Taft
[1.1.1.1.1.2.2.13.6.1]
b. 4 Jun 1806 d. 22 Feb 1889
Sarah Jane Hagar
b. 16 Dec 1810 d. 25 Sep 1852
11
Louis V Taft
[1.1.1.1.1.2.2.13.6.1.1]
b. 2 Oct 1831
11
Abby Jane Taft
[1.1.1.1.1.2.2.13.6.1.2]
b. 30 Oct 1836 d. 1906
11
Georgiana Taft
[1.1.1.1.1.2.2.13.6.1.3]
b. 31 Mar 1839 d. 9 Oct 1918
11
James K Polk Taft
[1.1.1.1.1.2.2.13.6.1.4]
b. 17 May 1847 d. 15 Sep 1847
11
Sarah Taft
[1.1.1.1.1.2.2.13.6.1.5]
b. 21 Sep 1852 d. 21 Sep 1852
Katharine Edwards
b. 22 Dec 1815 d. 22 Feb 1878
11
Henry Taft
[1.1.1.1.1.2.2.13.6.1.6]
b. 12 Nov 1854 d. 12 Nov 1854
11
Edward Taft
[1.1.1.1.1.2.2.13.6.1.7]
b. 7 Feb 1858 d. 9 May 1930
10
Benjamin B Taft
[1.1.1.1.1.2.2.13.6.2]
b. 28 Feb 1808
9
Samuel Taft
[1.1.1.1.1.2.2.13.7]
b. 18 Oct 1788 d. 20 Oct 1859
9
Elisha Taft
[1.1.1.1.1.2.2.13.8]
b. 15 Feb 1791 d. 26 Dec 1849
9
Elizabeth Taft
[1.1.1.1.1.2.2.13.9]
b. 2 Feb 1795
8
Phila Taft
[1.1.1.1.1.2.2.14]
b. Abt 1748 d. 1794
7
Mary Taft
[1.1.1.1.1.2.3]
b. 21 Dec 1700 d. 1755
Benjamin Albee
b. 1 Nov 1694 d. 24 Jun 1755
8
Deacon Gideon Albee
[1.1.1.1.1.2.3.1]
b. 1 Mar 1723 d. 18 Oct 1799
8
Susanna Albee
[1.1.1.1.1.2.3.2]
b. Abt 1725 d. 8 Aug 1802
8
Jemima Albee
[1.1.1.1.1.2.3.3]
b. 7 Oct 1731 d. 7 Oct 1782
8
Peter Albee
[1.1.1.1.1.2.3.4]
b. 19 Jan 1736
8
Stephen Albee
[1.1.1.1.1.2.3.5]
b. Abt 1740
7
Elizabeth Taft
[1.1.1.1.1.2.4]
b. 18 Jun 1704 d. 1748
Peter Marvel
b. 1700 d. 26 Sep 1735
8
Margaret Marvel
[1.1.1.1.1.2.4.1]
b. Abt 1729
8
Tristan Marvel
[1.1.1.1.1.2.4.2]
b. Abt 1730 d. 29 Feb 1748
7
Alice Taft
[1.1.1.1.1.2.5]
b. 27 Jun 1707
+
Briggs
b. Abt 1700 d. Aft 1727
7
Eunice Taft
[1.1.1.1.1.2.6]
b. 20 Feb 1709 d. 27 Feb 1787
Obadiah Walker
b. 9 Oct 1691 d. 9 Jun 1760
8
Benjamin Walker
[1.1.1.1.1.2.6.1]
b. 30 Sep 1746 d. Bef 23 Nov 1813
7
John Taft
[1.1.1.1.1.2.7]
b. 18 Dec 1710 d. 19 Apr 1769
Hannah Cheney
b. 13 Feb 1711 d. 22 Feb 1759
8
Eunice Taft
[1.1.1.1.1.2.7.1]
b. 18 Jun 1735
Colonel Joseph Reed
b. 6 Mar 1731
9
Nathan Reed
[1.1.1.1.1.2.7.1.1]
b. 9 Dec 1754
9
Eunice Reed
[1.1.1.1.1.2.7.1.2]
b. 26 Dec 1755
9
Major Cheney Reed
[1.1.1.1.1.2.7.1.3]
b. Abt 1759 d. 18 May 1822
9
Joseph Reed
[1.1.1.1.1.2.7.1.4]
b. 1 Sep 1760
9
Hannah Reed
[1.1.1.1.1.2.7.1.5]
b. 24 Jul 1762
8
Hannah Taft
[1.1.1.1.1.2.7.2]
b. 4 Jul 1737 d. 2 Feb 1740
8
John Taft
[1.1.1.1.1.2.7.3]
b. 2 Jan 1740 d. 1 Feb 1808
Mary Harwood
b. 10 Jun 1745 d. 2 Jun 1782
9
Susanna Taft
[1.1.1.1.1.2.7.3.1]
b. 6 Mar 1763 d. 12 Feb 1846
9
Olive Taft
[1.1.1.1.1.2.7.3.2]
b. 11 Apr 1765
9
Margary Taft
[1.1.1.1.1.2.7.3.3]
b. 21 Aug 1767
9
Hulda Taft
[1.1.1.1.1.2.7.3.4]
b. 7 Apr 1770
8
Hannah Taft
[1.1.1.1.1.2.7.4]
b. 5 Jun 1744
8
Bethiah Taft
[1.1.1.1.1.2.7.5]
b. 9 Aug 1747
8
Robert Taft
[1.1.1.1.1.2.7.6]
b. 21 Jul 1749
Chloe Taft
b. 7 Jun 1753 d. 17 Oct 1843
9
Hannah Taft
[1.1.1.1.1.2.7.6.1]
b. 21 Mar 1772 d. 3 Aug 1802
9
Josiah Taft
[1.1.1.1.1.2.7.6.2]
b. 6 Jul 1776 d. 1845
9
Abigail Taft
[1.1.1.1.1.2.7.6.3]
b. 17 Aug 1778 d. 31 Oct 1850
9
Jesse Taft
[1.1.1.1.1.2.7.6.4]
b. 3 Feb 1781 d. 10 Jun 1783
9
Jesse Taft
[1.1.1.1.1.2.7.6.5]
b. 30 Apr 1782 d. 15 Oct 1869
9
Chloe Taft
[1.1.1.1.1.2.7.6.6]
b. 20 Jan 1786 d. 1809
9
Robert Taft
[1.1.1.1.1.2.7.6.7]
b. 26 Nov 1788 d. 16 Apr 1865
8
Josiah Taft
[1.1.1.1.1.2.7.7]
b. 29 Nov 1752
8
Mary Taft
[1.1.1.1.1.2.7.8]
b. 14 Feb 1753 d. 19 Jul 1832
Jacob Taft
b. 1 Dec 1751 d. 30 May 1823
9
Lois Taft
[1.1.1.1.1.2.7.8.1]
b. 27 Aug 1780 d. 27 Apr 1854
Josiah Seagrave
b. 14 Oct 1773 d. 20 Mar 1855
10
Mary Ann Seagrave
[1.1.1.1.1.2.7.8.1.1]
b. 17 Nov 1799 d. 10 Feb 1825
10
Jacob Taft Seagraves
[1.1.1.1.1.2.7.8.1.2]
b. 8 Apr 1802 d. 24 Sep 1870
10
Henrietta Frost Seagrave
[1.1.1.1.1.2.7.8.1.3]
b. 1 Dec 1803 d. 1 Jun 1823
10
Waity Grant Seagrave
[1.1.1.1.1.2.7.8.1.4]
b. 23 Sep 1805 d. 27 Jan 1859
10
Edward Seagrave
[1.1.1.1.1.2.7.8.1.5]
b. 3 Sep 1807 d. 15 Feb 1873
10
Lois Taft Seagrave
[1.1.1.1.1.2.7.8.1.6]
b. 13 Apr 1809 d. 19 Mar 1853
10
Josiah Seagrave, Jr
[1.1.1.1.1.2.7.8.1.7]
b. 24 May 1811 d. 21 Jul 1861
10
Malvina Seagrave
[1.1.1.1.1.2.7.8.1.8]
b. 2 Apr 1813 d. 16 Dec 1823
10
Caleb Seagrave
[1.1.1.1.1.2.7.8.1.9]
b. 8 Feb 1815 d. 14 Nov 1823
10
Son Seagrave
[1.1.1.1.1.2.7.8.1.10]
b. 3 May 1817 d. 3 May 1817
10
Daughter Seagrave
[1.1.1.1.1.2.7.8.1.11]
b. 3 May 1817 d. 3 May 1817
10
Esborn Seagrave
[1.1.1.1.1.2.7.8.1.12]
b. 28 Dec 1818 d. 27 Oct 1856
10
George Augustus Seagrave
[1.1.1.1.1.2.7.8.1.13]
b. 6 Jan 1823 d. 15 Nov 1884
9
Hannah Margaret Taft
[1.1.1.1.1.2.7.8.2]
b. 28 Nov 1782 d. 2 Apr 1857
Stephen Carpenter
b. 13 Aug 1778 d. 1 Oct 1854
10
Eunice Carpenter
[1.1.1.1.1.2.7.8.2.1]
b. Sep 1802 d. Mar 1864
10
Orsmus T Carpenter
[1.1.1.1.1.2.7.8.2.2]
b. Jan 1805 d. 4 Apr 1863
10
Joseph Rawson Carpenter
[1.1.1.1.1.2.7.8.2.3]
b. 2 Apr 1807 d. May 1839
10
Charlotte Taft Carpenter
[1.1.1.1.1.2.7.8.2.4]
b. 4 Feb 1809 d. 5 Sep 1845
10
Charles A Carpenter
[1.1.1.1.1.2.7.8.2.5]
b. 11 Feb 1813 d. 12 Aug 1887
10
Mary T Carpenter
[1.1.1.1.1.2.7.8.2.6]
b. 1815
10
Hannah Taft Carpenter
[1.1.1.1.1.2.7.8.2.7]
b. 20 Aug 1817 d. 17 Dec 1890
10
Nancy Carter Carpenter
[1.1.1.1.1.2.7.8.2.8]
b. 5 Jun 1820 d. 15 May 1898
10
Henrietta Carpenter
[1.1.1.1.1.2.7.8.2.9]
b. Apr 1823 d. Feb 1847
10
George Carpenter
[1.1.1.1.1.2.7.8.2.10]
b. 13 Jan 1825
9
Elisabeth Taft
[1.1.1.1.1.2.7.8.3]
b. 8 Nov 1784
Ephraim Taft
b. 18 Aug 1780
10
Mary Ann Taft
[1.1.1.1.1.2.7.8.3.1]
b. 22 May 1805
10
Ephriam Taft
[1.1.1.1.1.2.7.8.3.2]
b. 8 Feb 1807
9
Mary Taft
[1.1.1.1.1.2.7.8.4]
b. 16 Mar 1786 d. 25 Feb 1860
9
Charlotte Taft
[1.1.1.1.1.2.7.8.5]
b. 25 Feb 1789
9
John Taft
[1.1.1.1.1.2.7.8.6]
b. 3 Dec 1792 d. 29 May 1826
Lucretia Newell
b. 24 Sep 1795 d. 29 Dec 1863
10
Robert Taft
[1.1.1.1.1.2.7.8.6.1]
b. 27 May 1819
10
Jacob Taft
[1.1.1.1.1.2.7.8.6.2]
b. 19 May 1823
9
Orsmus Taft
[1.1.1.1.1.2.7.8.7]
b. 1 Jan 1795
Deborah White
b. 16 Feb 1722 d. 26 Oct 1806
8
Nathan Taft
[1.1.1.1.1.2.7.9]
b. 20 Oct 1766
8
Samuel Taft
[1.1.1.1.1.2.7.10]
b. 6 Feb 1769
7
Jemima Taft
[1.1.1.1.1.2.8]
b. 1 Apr 1713 d. 14 Oct 1787
Peter White
b. 6 Dec 1714 d. 8 May 1782
8
Joseph White
[1.1.1.1.1.2.8.1]
b. 25 Jun 1738 d. 1805
8
Bethaih White
[1.1.1.1.1.2.8.2]
b. 1 Mar 1740 d. 1809
8
Elisabeth White
[1.1.1.1.1.2.8.3]
b. 13 Dec 1743
8
Peter White
[1.1.1.1.1.2.8.4]
b. 1746 d. 2 Dec 1821
8
Jemima White
[1.1.1.1.1.2.8.5]
b. Abt 1754 d. Abt 1782
8
Nathan White
[1.1.1.1.1.2.8.6]
b. 10 Jan 1755 d. 21 Jan 1828
7
Gideon Taft
[1.1.1.1.1.2.9]
b. 4 Oct 1715 d. 1761
Elizabeth
b. Abt 1715
8
Nathan Taft
[1.1.1.1.1.2.9.1]
b. Abt 1735 d. 1 Dec 1741
8
Jemima Taft
[1.1.1.1.1.2.9.2]
b. 8 Sep 1736 d. 1 Aug 1742
8
Gideon Taft
[1.1.1.1.1.2.9.3]
b. 10 Nov 1738
8
Timothy Taft
[1.1.1.1.1.2.9.4]
b. 10 Sep 1740 d. 23 Nov 1741
8
Asa Taft
[1.1.1.1.1.2.9.5]
b. 8 May 1747 d. 10 Dec 1802
8
Elizabeth Taft
[1.1.1.1.1.2.9.6]
b. 1 Mar 1750
8
Phineas Taft
[1.1.1.1.1.2.9.7]
b. 29 Jan 1754 d. 6 Nov 1828
Jemima Thomson
b. 26 Jan 1752 d. 2 Dec 1837
9
Gideon Taft
[1.1.1.1.1.2.9.7.1]
b. 2 Mar 1776 d. 17 Nov 1859
9
David Taft
[1.1.1.1.1.2.9.7.2]
b. 1777 d. 1812
9
Mary Susan Taft
[1.1.1.1.1.2.9.7.3]
b. 1 Dec 1782 d. 28 Nov 1862
9
Cynthia Taft
[1.1.1.1.1.2.9.7.4]
b. Abt 1780 d. 8 Feb 1877
9
Otis Taft
[1.1.1.1.1.2.9.7.5]
b. 1785 d. 23 Apr 1855
9
Phineas Taft
[1.1.1.1.1.2.9.7.6]
b. 1790
9
Crispin Taft
[1.1.1.1.1.2.9.7.7]
b. 10 Feb 1793 d. 30 Jun 1862
8
Louise Taft
[1.1.1.1.1.2.9.8]
b. Jul 1756
6
Daniel Taft
[1.1.1.1.1.3]
b. 1677 d. 24 Aug 1761
Lydia Chapin
b. 29 Sep 1677 d. 31 Mar 1758
7
Abigail Taft
[1.1.1.1.1.3.1]
b. 14 Sep 1707 d. 1736
Abraham Staples
b. 3 Apr 1706 d. Aug 1767
8
Debarah Staples
[1.1.1.1.1.3.1.1]
b. 16 Oct 1727
8
Abigail Staples
[1.1.1.1.1.3.1.2]
b. 12 Oct 1729 d. 31 Dec 1813
Benoni Benson
b. 18 Jul 1724 d. 10 Jan 1806
9
Henry Benson
[1.1.1.1.1.3.1.2.1]
b. Abt 1778
9
Joseph Benson
[1.1.1.1.1.3.1.2.2]
b. Abt 1784
8
Abraham Staples
[1.1.1.1.1.3.1.3]
b. 4 Apr 1731 d. 20 Oct 1803
Marcy Harvey
b. 1 Jun 1731 d. 1772
9
Jonathan Staples
[1.1.1.1.1.3.1.3.1]
b. 29 Mar 1754 d. 28 Nov 1832
Rachel Holbrook
b. 6 Nov 1753 d. 9 Mar 1832
10
Sally Staples
[1.1.1.1.1.3.1.3.1.1]
b. 3 Oct 1779
10
Sylvia Staples
[1.1.1.1.1.3.1.3.1.2]
b. 2 Jan 1781 d. 13 Mar 1852
10
Rachael Staples
[1.1.1.1.1.3.1.3.1.3]
b. Abt 1784 d. 12 Dec 1870
10
Ellery Staples
[1.1.1.1.1.3.1.3.1.4]
b. 1784 d. 1861
10
Willard Staples
[1.1.1.1.1.3.1.3.1.5]
b. 20 Dec 1785 d. 20 Dec 1858
10
Jonathan Staples
[1.1.1.1.1.3.1.3.1.6]
b. 1792
9
George Staples
[1.1.1.1.1.3.1.3.2]
b. 9 Mar 1756 d. 23 Sep 1820
9
Abagail Staples
[1.1.1.1.1.3.1.3.3]
b. 9 Aug 1758 d. 1825
9
Lydia Staples
[1.1.1.1.1.3.1.3.4]
b. 5 Feb 1761 d. 12 Dec 1818
9
Abraham Staples
[1.1.1.1.1.3.1.3.5]
b. 13 Aug 1766
9
Jacob Staples
[1.1.1.1.1.3.1.3.6]
b. 2 Oct 1768
9
Mary Staples
[1.1.1.1.1.3.1.3.7]
b. 10 Mar 1772
Ruth Daniels
b. 13 Jul 1738 d. 26 Sep 1798
9
Ruth Staples
[1.1.1.1.1.3.1.3.8]
b. 22 Feb 1775 d. 10 Aug 1851
Elias Thayer
b. 3 May 1773 d. 26 Jun 1833
10
Hannah Ellis Thayer
[1.1.1.1.1.3.1.3.8.1]
b. 19 Mar 1800 d. 26 Feb 1818
Charles Benson Jenckes
b. 10 Apr 1796 d. Aft 1831
11
Charles T Jenckes
[1.1.1.1.1.3.1.3.8.1.1]
b. 20 Feb 1818 d. 28 Feb 1818
10
Ruth Daniels Thayer
[1.1.1.1.1.3.1.3.8.2]
b. 16 Jul 1802
10
Mary Blake Thayer
[1.1.1.1.1.3.1.3.8.3]
b. 26 Nov 1804 d. 1870
10
Elias Thayer
[1.1.1.1.1.3.1.3.8.4]
b. 28 Oct 1806 d. 2 Nov 1808
10
Julia Ann Thayer
[1.1.1.1.1.3.1.3.8.5]
b. 13 Dec 1808 d. 6 Aug 1833
10
Lyman Wheelock Thayer
[1.1.1.1.1.3.1.3.8.6]
b. 6 May 1798 d. 5 Apr 1848
10
Susan Thayer
[1.1.1.1.1.3.1.3.8.7]
b. 1 Feb 1811 d. 7 Apr 1812
10
Elias Nelson Thayer
[1.1.1.1.1.3.1.3.8.8]
b. 3 Apr 1814 d. 6 Aug 1835
10
John Milton Thayer
[1.1.1.1.1.3.1.3.8.9]
b. 24 Jan 1820 d. 19 Mar 1906
9
Lendol Staples
[1.1.1.1.1.3.1.3.9]
b. 1777
9
Susannah Staples
[1.1.1.1.1.3.1.3.10]
b. 21 Jul 1780 d. 11 Feb 1818
8
Lydia Staples
[1.1.1.1.1.3.1.4]
b. 1746 d. Abt 1843
7
Josiah Taft
[1.1.1.1.1.3.2]
b. 2 Apr 1709 d. 30 Sep 1756
Lydia Chapin
b. 2 Feb 1711 d. 9 Nov 1778
8
Josiah Taft
[1.1.1.1.1.3.2.1]
b. 10 May 1733 d. 18 Aug 1761
8
Ebenezer Taft
[1.1.1.1.1.3.2.2]
b. 20 Aug 1735 d. 16 Oct 1735
8
Caleb Taft
[1.1.1.1.1.3.2.3]
b. 1738 d. 19 Sep 1756
8
Asahael Taft
[1.1.1.1.1.3.2.4]
b. 23 Apr 1740
8
Joel Taft
[1.1.1.1.1.3.2.5]
b. 15 Aug 1742 d. 23 Dec 1745
8
Joel Taft
[1.1.1.1.1.3.2.6]
b. 19 Feb 1747 d. 30 Aug 1749
8
Barzillai Taft
[1.1.1.1.1.3.2.7]
b. 3 Nov 1750 d. 21 Jan 1839
Abigail Taft
b. 5 Oct 1754 d. 12 Aug 1775
9
Eunice Taft
[1.1.1.1.1.3.2.7.1]
b. 28 Jan 1775 d. 30 May 1861
Phineas Chapin
b. 3 Aug 1769 d. 3 May 1839
10
Abby Chapin
[1.1.1.1.1.3.2.7.1.1]
b. 1 Feb 1796
10
Laurinda Chapin
[1.1.1.1.1.3.2.7.1.2]
b. 6 Feb 1798 d. 20 Dec 1866
10
Sarah Richardson Chapin
[1.1.1.1.1.3.2.7.1.3]
b. 30 Apr 1800 d. 16 Apr 1884
10
Chloe T Chapin
[1.1.1.1.1.3.2.7.1.4]
b. 8 Apr 1802 d. 5 Oct 1881
10
Mary Warren Chapin
[1.1.1.1.1.3.2.7.1.5]
b. 27 Feb 1804 d. 13 Nov 1890
10
Caleb Chapin
[1.1.1.1.1.3.2.7.1.6]
b. 6 Feb 1806 d. 27 Sep 1883
Clarissa Wood Taft
b. 3 May 1810 d. 1889
11
Eunice Chapin
[1.1.1.1.1.3.2.7.1.6.1]
b. 1 May 1832 d. 29 Sep 1920
Samuel Mills Capron
b. 15 May 1832 d. 4 Jan 1874
12
Helen Maria Capron
[1.1.1.1.1.3.2.7.1.6.1.1]
b. 26 Mar 1858 d. 6 Jan 1863
12
Alice Louise Capron
[1.1.1.1.1.3.2.7.1.6.1.2]
b. 26 Mar 1862 d. 13 Jan 1863
12
Clara D Capron
[1.1.1.1.1.3.2.7.1.6.1.3]
b. 4 Aug 1864
12
Bertha C Capron
[1.1.1.1.1.3.2.7.1.6.1.4]
b. 16 Mar 1868 [
=>
]
12
William Cargill Capron
[1.1.1.1.1.3.2.7.1.6.1.5]
b. 27 Jul 1869 [
=>
]
11
Ezra Wood Chapin
[1.1.1.1.1.3.2.7.1.6.2]
b. 7 Jun 1836 d. 31 Mar 1909
Ellen Frances Cooper
b. 30 Dec 1835
12
Janet Chapin
[1.1.1.1.1.3.2.7.1.6.2.1]
b. 28 May 1870
11
Edwin Chapin
[1.1.1.1.1.3.2.7.1.6.3]
b. 7 Jun 1836 d. 27 Sep 1836
10
Margaret Ann Chapin
[1.1.1.1.1.3.2.7.1.7]
b. 16 Jun 1808 d. 15 Nov 1897
10
Bezaileel Taft Chapin
[1.1.1.1.1.3.2.7.1.8]
b. 21 Oct 1810 d. 28 May 1855
10
Samuel Judson Chapin
[1.1.1.1.1.3.2.7.1.9]
b. 27 Aug 1812 d. 18 Nov 1908
10
Son Chapin
[1.1.1.1.1.3.2.7.1.10]
b. 15 Oct 1815
10
Gardner Spring Chapin
[1.1.1.1.1.3.2.7.1.11]
b. 2 Oct 1817 d. 4 Aug 1892
10
Josiah Spring Chapin
[1.1.1.1.1.3.2.7.1.12]
b. 24 Aug 1820 d. 26 Dec 1882
Sarah Richardson
b. 26 Sep 1756 d. 27 Apr 1809
9
Abigail Taft
[1.1.1.1.1.3.2.7.2]
b. 5 Dec 1777 d. 24 Sep 1778
9
Bezaleel Taft
[1.1.1.1.1.3.2.7.3]
b. 8 Sep 1780 d. 16 Jul 1846
9
Sally Taft
[1.1.1.1.1.3.2.7.4]
b. 2 Nov 1783 d. 12 Nov 1808
9
Caleb Taft
[1.1.1.1.1.3.2.7.5]
b. 20 Dec 1786 d. 3 Nov 1805
9
Chloe Taft
[1.1.1.1.1.3.2.7.6]
b. 10 Mar 1793 d. 3 Apr 1869
8
Chloe Taft
[1.1.1.1.1.3.2.8]
b. 7 Jun 1753 d. 17 Oct 1843
Robert Taft
b. 21 Jul 1749
9
Hannah Taft
[1.1.1.1.1.3.2.8.1]
b. 21 Mar 1772 d. 3 Aug 1802
9
Josiah Taft
[1.1.1.1.1.3.2.8.2]
b. 6 Jul 1776 d. 1845
9
Abigail Taft
[1.1.1.1.1.3.2.8.3]
b. 17 Aug 1778 d. 31 Oct 1850
9
Jesse Taft
[1.1.1.1.1.3.2.8.4]
b. 3 Feb 1781 d. 10 Jun 1783
9
Jesse Taft
[1.1.1.1.1.3.2.8.5]
b. 30 Apr 1782 d. 15 Oct 1869
9
Chloe Taft
[1.1.1.1.1.3.2.8.6]
b. 20 Jan 1786 d. 1809
9
Robert Taft
[1.1.1.1.1.3.2.8.7]
b. 26 Nov 1788 d. 16 Apr 1865
7
David Taft
[1.1.1.1.1.3.3]
b. 19 Apr 1711 d. 12 Oct 1756
Johanna Lovett
b. 12 May 1714 d. 25 Apr 1776
8
David Taft
[1.1.1.1.1.3.3.1]
b. 1736 d. 3 Sep 1769
8
Abigail Taft
[1.1.1.1.1.3.3.2]
b. 21 Jun 1739 d. Bef 1769
8
Phineas Taft
[1.1.1.1.1.3.3.3]
b. Abt 1741 d. 16 Jan 1745
8
Ephraim Taft
[1.1.1.1.1.3.3.4]
b. 14 Jul 1749
8
Joanna Taft
[1.1.1.1.1.3.3.5]
b. 14 Nov 1751 d. 3 Oct 1777
John Benson
b. 1 Aug 1749 d. 18 May 1818
9
Lovett Benson
[1.1.1.1.1.3.3.5.1]
b. 6 Oct 1772 d. 4 Mar 1773
9
Lois Benson
[1.1.1.1.1.3.3.5.2]
b. 17 Jul 1774 d. 10 Jul 1840
Manassah Baker
b. 4 Oct 1765 d. 30 Jun 1831
10
Sarah Williams Baker
[1.1.1.1.1.3.3.5.2.1]
b. 8 Feb 1796
Andre Taft
b. 25 Jun 1792 d. 26 Jun 1850
11
Margary Ann Taft
[1.1.1.1.1.3.3.5.2.1.1]
b. 4 May 1818 d. 4 Nov 1904
Charles W Hartwell
b. 1816 d. Bef 1904
12
Margery Hartwell
[1.1.1.1.1.3.3.5.2.1.1.1]
b. 30 Oct 1849
11
Caroline Taft
[1.1.1.1.1.3.3.5.2.1.2]
b. 21 Aug 1821 d. 7 Nov 1907
John Flint Smith
b. 7 Nov 1815
12
Mary Flint Smith
[1.1.1.1.1.3.3.5.2.1.2.1]
b. 31 Mar 1850 d. 21 Aug 1852
12
Effie Caroline Smith
[1.1.1.1.1.3.3.5.2.1.2.2]
b. 28 Nov 1857 d. Aft 1902
10
Sawyer Baker
[1.1.1.1.1.3.3.5.2.2]
b. 5 Nov 1797 d. 14 Oct 1802
10
Mary Sawyer Baker
[1.1.1.1.1.3.3.5.2.3]
b. 1 Apr 1800
10
Bezaleel Sawyer Baker
[1.1.1.1.1.3.3.5.2.4]
b. 13 Sep 1802
10
William Henry Baker
[1.1.1.1.1.3.3.5.2.5]
b. 8 Jun 1805
10
Chloe Taft Baker
[1.1.1.1.1.3.3.5.2.6]
b. 17 Dec 1807
Faton Walker
11
Henry E Walker
[1.1.1.1.1.3.3.5.2.6.1]
b. 15 Mar 1836
11
Harriet E Walker
[1.1.1.1.1.3.3.5.2.6.2]
b. 15 Mar 1836 d. 30 Nov 1837
11
Edmund Walker
[1.1.1.1.1.3.3.5.2.6.3]
b. 18 Dec 1837 d. 10 May 1844
11
Edgar Walker
[1.1.1.1.1.3.3.5.2.6.4]
b. 18 Dec 1837 d. 24 Jan 1844
11
Adeline N Walker
[1.1.1.1.1.3.3.5.2.6.5]
b. 7 Feb 1845 d. 1848
10
John William Baker
[1.1.1.1.1.3.3.5.2.7]
b. 29 Sep 1810
10
Hannah Dike Baker
[1.1.1.1.1.3.3.5.2.8]
b. 8 Nov 1813 d. 3 Jul 1836
10
John Brooks Baker
[1.1.1.1.1.3.3.5.2.9]
b. 30 Jul 1816
10
Caleb Strong Baker
[1.1.1.1.1.3.3.5.2.10]
b. 30 Jul 1816 d. 29 Dec 1834
9
Prudence Benson
[1.1.1.1.1.3.3.5.3]
b. 4 May 1776 d. 16 May 1789
8
James Taft
[1.1.1.1.1.3.3.6]
b. 25 Oct 1754 d. 14 Oct 1756
7
Lydia Taft
[1.1.1.1.1.3.4]
b. 13 Apr 1713 d. 17 Aug 1793
Charles Sheldon
b. Abt 1709 d. 20 Jul 1763
8
Timothy Sheldon
[1.1.1.1.1.3.4.1]
b. 17 Feb 1739 d. 1757
8
Lydia Sheldon
[1.1.1.1.1.3.4.2]
b. 1742 d. 1757
8
Daniel Sheldon
[1.1.1.1.1.3.4.3]
b. 8 Jan 1743 d. Feb 1821
8
Charles Sheldon
[1.1.1.1.1.3.4.4]
b. 26 Aug 1746 d. 14 Mar 1832
8
Hannah Sheldon
[1.1.1.1.1.3.4.5]
b. 10 Jul 1751 d. 11 Jun 1783
8
Ephraim Sheldon
[1.1.1.1.1.3.4.6]
b. 21 May 1754 d. 22 Apr 1840
7
Daniel Taft
[1.1.1.1.1.3.5]
b. 15 Apr 1715 d. 1761
Hopestill White
b. 15 Jul 1717
8
Mary Taft
[1.1.1.1.1.3.5.1]
b. Abt 1737 d. 24 Dec 1817
8
Comfort Taft
[1.1.1.1.1.3.5.2]
b. Abt 1739 d. 16 Mar 1824
8
Beulah Taft
[1.1.1.1.1.3.5.3]
b. 10 Feb 1740 d. Dec 1828
8
Hephzibah Taft
[1.1.1.1.1.3.5.4]
b. 10 Feb 1740 d. Bef 1749
8
Amos Taft
[1.1.1.1.1.3.5.5]
b. 25 Apr 1745 d. Sep 1767
8
Deborah Taft
[1.1.1.1.1.3.5.6]
b. 6 Apr 1747
8
Hopestill Taft
[1.1.1.1.1.3.5.7]
b. 4 Jan 1749 d. Jun 1840
8
Daniel Taft
[1.1.1.1.1.3.5.8]
b. 22 Jul 1751 d. 12 May 1810
8
Jehoshaba Taft
[1.1.1.1.1.3.5.9]
b. 1755
8
Alpheus Taft
[1.1.1.1.1.3.5.10]
b. 11 Jan 1757
8
Zadoch Taft
[1.1.1.1.1.3.5.11]
b. 4 Feb 1759
8
Patience Taft
[1.1.1.1.1.3.5.12]
b. 16 Nov 1762 d. 12 May 1810
7
Japhet Taft
[1.1.1.1.1.3.6]
b. 24 Mar 1721 d. 24 Aug 1761
7
Caleb Taft
[1.1.1.1.1.3.7]
b. 1724 d. 1762
7
Ephraim Taft
[1.1.1.1.1.3.8]
b. 25 May 1718 d. 6 May 1748
Anna Read
b. 25 Oct 1728 d. 12 Mar 1797
8
Anna Taft
[1.1.1.1.1.3.8.1]
b. 14 Apr 1748 d. 3 Apr 1830
Stephen Taft
b. 21 Aug 1734 d. 3 Feb 1803
9
Lydia Taft
[1.1.1.1.1.3.8.1.1]
b. 13 Oct 1766 d. 13 Jan 1847
9
Hazeltine Taft
[1.1.1.1.1.3.8.1.2]
b. 6 Jan 1769 d. 18 Jul 1856
9
Gravenor Taft
[1.1.1.1.1.3.8.1.3]
b. 1773 d. 1838
9
Marcy Taft
[1.1.1.1.1.3.8.1.4]
b. 5 Sep 1775
9
Ephraim Taft
[1.1.1.1.1.3.8.1.5]
b. 18 Aug 1780
Elisabeth Taft
b. 8 Nov 1784
10
Mary Ann Taft
[1.1.1.1.1.3.8.1.5.1]
b. 22 May 1805
10
Ephriam Taft
[1.1.1.1.1.3.8.1.5.2]
b. 8 Feb 1807
9
Lovice Taft
[1.1.1.1.1.3.8.1.6]
b. 1 Jul 1783
9
Anna Taft
[1.1.1.1.1.3.8.1.7]
b. 29 Nov 1784
9
Stephen Taft
[1.1.1.1.1.3.8.1.8]
b. 12 Dec 1787
9
Adolphas Taft
[1.1.1.1.1.3.8.1.9]
b. 2 Oct 1791
6
Captain Joseph Taft
[1.1.1.1.1.4]
b. 1680 d. 18 Jun 1747
Elizabeth Emerson
b. 6 Mar 1686 d. 18 Jun 1747
7
Lucy Taft
[1.1.1.1.1.4.1]
b. 22 Sep 1709
7
Lieutenant Moses Taft
[1.1.1.1.1.4.2]
b. 30 Jan 1712 d. 16 Jul 1778
Priscilla Thayer
b. 6 Jun 1717 d. Aft 1761
8
Lieutenant Abner Taft
[1.1.1.1.1.4.2.1]
b. 28 Dec 1736 d. 30 May 1809
Tryal White
b. 8 May 1737 d. 14 Jun 1814
9
Oliver Taft
[1.1.1.1.1.4.2.1.1]
b. 1 May 1758 d. 16 Jul 1775
9
Moses Taft
[1.1.1.1.1.4.2.1.2]
b. 29 Sep 1760 d. 4 Dec 1848
Judith Cummings
b. 26 Nov 1766 d. 26 Nov 1816
10
Nancy Taft
[1.1.1.1.1.4.2.1.2.1]
b. 10 Mar 1787
10
Samuel Taft
[1.1.1.1.1.4.2.1.2.2]
b. 24 Sep 1790 d. 11 Oct 1863
10
Lucy Taft
[1.1.1.1.1.4.2.1.2.3]
b. 24 Apr 1795 d. 21 Jun 1847
10
Newell Taft
[1.1.1.1.1.4.2.1.2.4]
b. 28 Jul 1804 d. 4 Nov 1873
Hannah G Taft
b. 18 May 1802 d. 8 Jan 1843
11
Albert Taft
[1.1.1.1.1.4.2.1.2.4.1]
b. 28 Aug 1823 d. Aft 1874
Sally L Bartlett
b. 14 Oct 1827 d. 1 Sep 1874
12
Charles B Taft
[1.1.1.1.1.4.2.1.2.4.1.1]
b. Feb 1854 d. 23 Sep 1854
12
Hannah L Taft
[1.1.1.1.1.4.2.1.2.4.1.2]
b. 5 Feb 1856
11
Marcy Taft
[1.1.1.1.1.4.2.1.2.4.2]
b. Mar 1829 d. 12 Apr 1830
11
Charles M Taft
[1.1.1.1.1.4.2.1.2.4.3]
b. Jan 1843 d. 7 Dec 1843
10
Sylvia Taft
[1.1.1.1.1.4.2.1.2.5]
b. 23 Aug 1810 d. 3 Aug 1816
9
Mary Taft
[1.1.1.1.1.4.2.1.3]
b. 12 Oct 1767 d. 18 Aug 1775
9
Webb Taft
[1.1.1.1.1.4.2.1.4]
b. 26 Mar 1772 d. 21 Apr 1842
Lucy Taft
b. 9 Jun 1774 d. 14 Mar 1846
10
Lucinda Taft
[1.1.1.1.1.4.2.1.4.1]
b. 22 Nov 1793
10
Jason Taft
[1.1.1.1.1.4.2.1.4.2]
b. 5 Jun 1796 d. 25 Oct 1861
9
Trial T Taft
[1.1.1.1.1.4.2.1.5]
b. 13 Apr 1777 d. 18 Aug 1815
8
James Taft
[1.1.1.1.1.4.2.2]
b. 9 Apr 1738 d. 14 Jan 1826
Esther Taft
b. 9 Jan 1747 d. 3 Feb 1834
9
Lucy Taft
[1.1.1.1.1.4.2.2.1]
b. 22 Nov 1769 d. 29 Jul 1845
Ebenezer Winslow
b. 21 Jan 1772 d. 21 Feb 1841
10
Albert Winslow
[1.1.1.1.1.4.2.2.1.1]
b. 24 Jul 1797
Sarah Gardner
b. 25 Jul 1803 d. 23 Sep 1840
11
Martha Maria Winslow
[1.1.1.1.1.4.2.2.1.1.1]
b. 12 Mar 1826 d. 16 Mar 1842
11
Preston Willard Winslow
[1.1.1.1.1.4.2.2.1.1.2]
b. 13 Nov 1828
Lucy Weatherbee
b. 16 Jul 1829 d. 8 Nov 1859
12
Mary Charlena Winslow
[1.1.1.1.1.4.2.2.1.1.2.1]
b. 22 Apr 1858
+
Maria Fuller
b. 12 Apr 1841
11
Mary Augusta Allen Winslow
[1.1.1.1.1.4.2.2.1.1.3]
b. 14 Sep 1831
+
Charles Warner
b. Abt 1830
11
John Alvin Winslow
[1.1.1.1.1.4.2.2.1.1.4]
b. 3 Jul 1834
11
Jasper Ross Winslow
[1.1.1.1.1.4.2.2.1.1.5]
b. 7 Apr 1837 d. 25 Oct 1841
11
Sarah Adaline Winslow
[1.1.1.1.1.4.2.2.1.1.6]
b. 20 Dec 1839 d. 9 Dec 1841
Sylvia Babbit
b. 27 Jan 1814
11
Jasper Albert Winslow
[1.1.1.1.1.4.2.2.1.1.7]
b. 15 Apr 1842 d. 14 Oct 1864
10
Claramond Winslow
[1.1.1.1.1.4.2.2.1.2]
b. 10 Feb 1799 d. 27 Apr 1834
John Hathaway
b. 22 May 1797
11
Son Hathaway
[1.1.1.1.1.4.2.2.1.2.1]
b. Apr 1828 d. 14 Apr 1828
11
Francis Ebenezer Hathaway
[1.1.1.1.1.4.2.2.1.2.2]
b. 9 Mar 1829
Lydia Carter
b. 24 Mar 1832
12
Hattie Carter Hathaway
[1.1.1.1.1.4.2.2.1.2.2.1]
b. 10 Jan 1865 d. 30 Oct 1958 [
=>
]
11
Catherine Elizabeth Hathaway
[1.1.1.1.1.4.2.2.1.2.3]
b. 18 Feb 1833
11
George H Hathaway
[1.1.1.1.1.4.2.2.1.2.4]
b. 13 Aug 1839
Abigail F Pomeroy
b. Abt 1843 d. 9 Feb 1891
12
Charles Edward Hathaway
[1.1.1.1.1.4.2.2.1.2.4.1]
b. 23 Oct 1866
10
Alvin Winslow
[1.1.1.1.1.4.2.2.1.3]
b. 27 Aug 1802 d. 9 Oct 1803
10
Paulina Maria Winslow
[1.1.1.1.1.4.2.2.1.4]
b. 27 May 1805
+
Austin Crosby
b. 10 Mar 1805 d. 13 Jun 1868
10
Lucy Emma Winslow
[1.1.1.1.1.4.2.2.1.5]
b. 17 Feb 1808 d. 20 Feb 1870
+
Matthew Henry McClary
b. 10 Mar 1801
9
Zilpha Taft
[1.1.1.1.1.4.2.2.2]
b. 1 Jul 1772 d. 24 Feb 1848
Nathan Fisher
b. 25 Jun 1770 d. 21 Mar 1847
10
Elias Fisher
[1.1.1.1.1.4.2.2.2.1]
b. 10 Jul 1796
10
Elise Fisher
[1.1.1.1.1.4.2.2.2.2]
b. 10 Jul 1796
10
Josiah Fisher
[1.1.1.1.1.4.2.2.2.3]
b. 26 Feb 1798 d. 11 Apr 1799
10
Josiah Fisher
[1.1.1.1.1.4.2.2.2.4]
b. 1 Dec 1801
10
Rachel Adaline Fisher
[1.1.1.1.1.4.2.2.2.5]
b. 29 Jan 1804
+
Moses Daniels Southwick
10
Mary Caroline Fisher
[1.1.1.1.1.4.2.2.2.6]
b. 22 Mar 1806
10
Nathan Fisher
[1.1.1.1.1.4.2.2.2.7]
b. 21 Mar 1811
9
Irena Taft
[1.1.1.1.1.4.2.2.3]
b. 25 Oct 1774 d. 29 May 1790
9
Ezekial Taft
[1.1.1.1.1.4.2.2.4]
b. 21 Jan 1777 d. 24 Apr 1841
+
Olive Thayer
b. 10 Aug 1782 d. 1865
9
James Taft
[1.1.1.1.1.4.2.2.5]
b. 13 Jun 1780
9
Luke Taft
[1.1.1.1.1.4.2.2.6]
b. 3 Jun 1783
Nancy Wood
b. 6 Feb 1787 d. 6 May 1859
10
Clarissa Wood Taft
[1.1.1.1.1.4.2.2.6.1]
b. 3 May 1810 d. 1889
Caleb Chapin
b. 6 Feb 1806 d. 27 Sep 1883
11
Eunice Chapin
[1.1.1.1.1.4.2.2.6.1.1]
b. 1 May 1832 d. 29 Sep 1920
Samuel Mills Capron
b. 15 May 1832 d. 4 Jan 1874
12
Helen Maria Capron
[1.1.1.1.1.4.2.2.6.1.1.1]
b. 26 Mar 1858 d. 6 Jan 1863
12
Alice Louise Capron
[1.1.1.1.1.4.2.2.6.1.1.2]
b. 26 Mar 1862 d. 13 Jan 1863
12
Clara D Capron
[1.1.1.1.1.4.2.2.6.1.1.3]
b. 4 Aug 1864
12
Bertha C Capron
[1.1.1.1.1.4.2.2.6.1.1.4]
b. 16 Mar 1868 [
=>
]
12
William Cargill Capron
[1.1.1.1.1.4.2.2.6.1.1.5]
b. 27 Jul 1869 [
=>
]
11
Ezra Wood Chapin
[1.1.1.1.1.4.2.2.6.1.2]
b. 7 Jun 1836 d. 31 Mar 1909
Ellen Frances Cooper
b. 30 Dec 1835
12
Janet Chapin
[1.1.1.1.1.4.2.2.6.1.2.1]
b. 28 May 1870
11
Edwin Chapin
[1.1.1.1.1.4.2.2.6.1.3]
b. 7 Jun 1836 d. 27 Sep 1836
10
Moses Taft
[1.1.1.1.1.4.2.2.6.2]
b. 26 Jan 1812
Sylvia Ann Wheelock
b. 3 Feb 1815 d. 3 Oct 1855
11
Sarah Wood Taft
[1.1.1.1.1.4.2.2.6.2.1]
b. 6 Jan 1838
Lewis Henry Murdock
b. 17 Mar 1835 d. 25 Mar 1916
12
Herbert Taft Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.6.2.1.1]
b. 11 Sep 1865 d. 29 Oct 1916 [
=>
]
12
Edgar Wheelock Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.6.2.1.2]
b. 1 Feb 1869 d. 13 Jun 1904
11
Susan Hortense Taft
[1.1.1.1.1.4.2.2.6.2.2]
b. 5 Jan 1843
11
Luke Herbert Taft
[1.1.1.1.1.4.2.2.6.2.3]
b. 9 Nov 1846
+
Helen Eugenia Bechet
10
Sarah Taft
[1.1.1.1.1.4.2.2.6.3]
b. 15 Jan 1815 d. 24 Dec 1898
Amariah Albee Wood
b. 2 Nov 1802 d. 14 Jun 1871
11
Sarah A Wood
[1.1.1.1.1.4.2.2.6.3.1]
b. May 1837 d. 26 Sep 1837
11
Samuel Taft Wood
[1.1.1.1.1.4.2.2.6.3.2]
b. 4 Oct 1841 d. Jun 1925
+
Olive DeWilton Seagrave
b. 17 Jul 1842 d. 7 Aug 1862
Mary E Rawson
b. 11 Sep 1845
12
Eva Gertrude Wood
[1.1.1.1.1.4.2.2.6.3.2.1]
b. 29 May 1865
12
Merritt D Wood
[1.1.1.1.1.4.2.2.6.3.2.2]
b. 2 Sep 1873
11
Mary Baylies Wood
[1.1.1.1.1.4.2.2.6.3.3]
b. 29 Apr 1847 d. 9 Sep 1847
11
Anna I Wood
[1.1.1.1.1.4.2.2.6.3.4]
b. 18 Aug 1848 d. 1919
10
Irene Taft
[1.1.1.1.1.4.2.2.6.4]
b. 19 Sep 1816 d. 26 Jan 1900
Silas Mandeville Wheelock
b. 11 Nov 1817 d. 18 Oct 1901
11
Ellen Maria Wheelock
[1.1.1.1.1.4.2.2.6.4.1]
b. 2 Sep 1842 d. 1871
11
Eugene Augustus Wheelock
[1.1.1.1.1.4.2.2.6.4.2]
b. 15 Feb 1846 d. 14 Sep 1912
Sarah Smith Taft
b. 17 Apr 1846
12
Silas Mandeville Wheelock
[1.1.1.1.1.4.2.2.6.4.2.1]
b. 10 Mar 1871 d. 22 Jun 1937 [
=>
]
12
Ellen Maria Wheelock
[1.1.1.1.1.4.2.2.6.4.2.2]
b. 20 Mar 1873 d. 12 Mar 1954
12
Mary Taft Wheelock
[1.1.1.1.1.4.2.2.6.4.2.3]
b. 8 Aug 1875 d. 21 Jul 1957
12
Irene Taft Wheelock
[1.1.1.1.1.4.2.2.6.4.2.4]
b. 7 Apr 1881 d. 2 Jan 1963
12
Henry Arnold Wheelock
[1.1.1.1.1.4.2.2.6.4.2.5]
b. 27 Aug 1883 d. 12 Jul 1954
+
Caroline Harper
11
Alice Augusta Wheelock
[1.1.1.1.1.4.2.2.6.4.3]
b. 22 Jan 1849 d. Sep 1891
11
Arthur Wheelock
[1.1.1.1.1.4.2.2.6.4.4]
b. 26 Mar 1851 d. 23 Sep 1927
Emogene Atchinson
b. 22 Sep 1851 d. 12 Apr 1898
12
Stanley H Wheelock
[1.1.1.1.1.4.2.2.6.4.4.1]
b. 15 Jul 1879 [
=>
]
12
Annie Atchinan Wheelock
[1.1.1.1.1.4.2.2.6.4.4.2]
b. 15 Jan 1887 d. 5 Oct 1918
+
Harriet E Fuller
b. 1845
11
Henry Wheelock
[1.1.1.1.1.4.2.2.6.4.5]
b. 14 Jan 1857 d. 13 Nov 1881
+
Jane Goulding Taft
b. 12 Oct 1856 d. 20 Jan 1931
10
Chloe M Taft
[1.1.1.1.1.4.2.2.6.5]
b. 5 Feb 1823
Luke Southwick Farnham
b. 20 Jan 1817 d. 23 Aug 1883
11
Elizabeth Southwick Farnham
[1.1.1.1.1.4.2.2.6.5.1]
b. 1852
+
Jerome Prentiss
11
Ella Frances Farnham
[1.1.1.1.1.4.2.2.6.5.2]
b. 1855
11
Moses Taft Farnham
[1.1.1.1.1.4.2.2.6.5.3]
b. 1858
11
Walter James Farnham
[1.1.1.1.1.4.2.2.6.5.4]
b. 1862
10
James Taft
[1.1.1.1.1.4.2.2.6.6]
b. 1830
9
Esther Taft
[1.1.1.1.1.4.2.2.7]
b. 5 Aug 1786 d. 10 Aug 1858
Fuller Murdock
b. 17 Feb 1781 d. 8 Nov 1857
10
Philena Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.1]
b. 26 Aug 1807 d. 30 Jun 1835
Samuel Merriam
b. Abt 1803
11
George Nison Merriam
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.1.1]
b. 26 Dec 1834 d. 19 Nov 1903
Ellen Jane Pickering
b. 27 Mar 1836 d. 15 Jan 1911
12
Josephine Louisa Merriam
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.1.1.1]
b. 29 Oct 1859 d. 14 Mar 1949
12
Nellie Pickering Merriam
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.1.1.2]
b. 26 Feb 1870 d. 20 Nov 1887
12
Flora N. Merriam
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.1.1.3]
b. 31 Mar 1872
10
Abba Eliza Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.2]
b. 13 Nov 1808 d. 4 Apr 1834
Pemberton Brown
b. 11 Oct 1801 d. 30 Mar 1870
11
Tarissa Gregory Brown
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.2.1]
b. 3 Oct 1828 d. 12 Oct 1914
John Conley Fisher
b. 25 May 1818 d. 1 Dec 1898
12
Paulina Agnes Fisher
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.2.1.1]
b. 2 Dec 1848 d. 2 Oct 1850
12
Elizabeth B Fisher
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.2.1.2]
b. 25 Jun 1853 d. 5 Nov 1933 [
=>
]
12
Alonzo Pemberton Fisher
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.2.1.3]
b. 11 Dec 1855 d. 21 Feb 1937 [
=>
]
12
Ida H. Fisher
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.2.1.4]
b. 1858
12
Lillian L. Fisher
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.2.1.5]
b. 2 Oct 1860
12
Malvern Adelbert Fisher
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.2.1.6]
b. 30 Mar 1863 [
=>
]
12
Georgene Fisher Gardner
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.2.1.7]
b. 12 Oct 1864 d. 17 Oct 1942 [
=>
]
12
Myrtella Fisher
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.2.1.8]
b. 30 Jul 1867
11
Josephine Brown
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.2.2]
b. 29 Jan 1830 d. 16 Jan 1895
William Brainerd Cadwell
b. 2 Sep 1832 d. 1870
12
Abbie Flora Cadwell
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.2.2.1]
b. 19 Oct 1854 d. 24 Sep 1937 [
=>
]
12
Etola Florence Cadwell
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.2.2.2]
b. 16 Jul 1857 d. 27 Dec 1937 [
=>
]
11
Adin Ballou Brown
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.2.3]
b. 14 Nov 1831 d. 19 Apr 1880
11
Edin Ballow Brown
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.2.4]
b. 14 Nov 1831
11
Abba Eliza Brown
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.2.5]
b. 30 Jun 1833 d. 19 Oct 1914
Abiel Copelin
b. 22 Jul 1834 d. 8 Jul 1907
12
Arthur A. Copelin
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.2.5.1]
b. 1859 d. 3 May 1884
12
Herbert A. Copelin
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.2.5.2]
b. 31 May 1867 d. 14 Aug 1867
10
Moses Taft Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.3]
b. 12 Sep 1810 d. 7 Feb 1883
Dorinda Wood Grout
b. 19 Aug 1810 d. 15 Jan 1888
11
Cyrus Grout Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.3.1]
b. 16 Jun 1833 d. 7 Jun 1913
Sarah Ann Aldrich
b. 3 Apr 1831 d. 1 Mar 1902
12
Son Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.3.1.1]
b. 20 May 1856 d. 20 May 1856
12
Lillian A Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.3.1.2]
b. 17 Apr 1857 d. 7 Dec 1927
12
Bertha Aldrich Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.3.1.3]
b. 15 May 1872 d. 12 Nov 1940
11
Lewis Henry Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.3.2]
b. 17 Mar 1835 d. 25 Mar 1916
Sarah Wood Taft
b. 6 Jan 1838
12
Herbert Taft Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.3.2.1]
b. 11 Sep 1865 d. 29 Oct 1916 [
=>
]
12
Edgar Wheelock Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.3.2.2]
b. 1 Feb 1869 d. 13 Jun 1904
11
Sarah A Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.3.3]
b. Jul 1837 d. 1 Sep 1838
11
Lucius Walter Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.3.4]
b. 11 Apr 1846 d. 1 Jul 1867
11
Samuel Justin Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.3.5]
b. 13 May 1848 d. 11 May 1910
Mary Brown
b. 1843 d. 11 Apr 1920
12
Lena D M Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.3.5.1]
b. 5 Mar 1871 d. 30 Jun 1871
12
Lewis F Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.3.5.2]
b. 18 May 1873
11
Lyman Wood Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.3.6]
b. 26 Dec 1853 d. Bef 1900
Elizabeth Ann Snowling
b. 16 Jan 1860 d. 17 Aug 1918
12
May A. Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.3.6.1]
b. 1881
12
Minnie Idella Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.3.6.2]
b. 19 Jun 1884
10
John Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.4]
b. 9 Sep 1812 d. 13 Sep 1837
10
Charles Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.5]
b. 11 Feb 1815 d. 6 Aug 1869
Mary Ann Weightman
b. 3 Apr 1823 d. 11 May 1895
11
Charles W Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.5.1]
b. 4 Mar 1854 d. 5 Mar 1916
Abba Loretta Wardwell
b. 29 Jan 1849 d. 12 Jun 1929
12
Leroy Eugene Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.5.1.1]
b. 22 Jan 1875 [
=>
]
12
Horace Sherman Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.5.1.2]
b. 27 May 1879 [
=>
]
10
Caleb Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.6]
b. 16 Feb 1817 d. 10 May 1892
Maria Howard Emerson
b. 27 Dec 1830 d. 11 Oct 1901
11
Frank Fuller Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.6.1]
b. 18 May 1857 d. 13 Jan 1939
Alice M Gardner
b. Apr 1868
12
Dorothy Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.6.1.1]
b. 27 Nov 1892 d. Jul 1978
12
Edwin Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.6.1.2]
b. 11 Jun 1896 d. Jun 1977
11
Herbert Emerson Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.6.2]
b. 16 Jan 1859 d. 18 Jan 1931
Nancy Sophia Brigham
b. 29 Sep 1862 d. 1 Mar 1943
12
Russell Brigham Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.6.2.1]
b. 7 Sep 1893 d. 20 Feb 1969
12
Phyllis Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.6.2.2]
b. 15 Nov 1895
12
Marjory Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.6.2.3]
b. 1896
11
Eugene Clifford Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.6.3]
b. 24 Nov 1863 d. 13 Sep 1924
+
Elizabeth Howland Hutchinson
b. 7 Dec 1856
11
Carrie Maria Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.6.4]
b. 4 Sep 1865
Edward Augustus Rich
b. 29 Jul 1844 d. Bef 1930
12
Priscilla Augusta Rich
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.6.4.1]
b. 19 Oct 1898 d. 13 Apr 1899
12
Edward Augustus Rich
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.6.4.2]
b. 19 May 1900 d. 2 Nov 1982
10
George Taft Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.7]
b. 18 Mar 1819
Abbie Ann Robinson
b. Abt 1825
11
George Thurston Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.7.1]
b. 4 Jul 1846 d. 30 Jan 1933
Arvilla Richardson Thayer
b. 4 Feb 1850 d. 29 Oct 1902
12
Mabel Florence Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.7.1.1]
b. 13 Dec 1875 d. Aft 1944 [
=>
]
11
Lizzie Green Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.7.2]
b. 2 Sep 1857 d. 3 May 1879
Horace Edward Bigelow
b. 9 Jun 1857
12
Daughter Bigelow
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.7.2.1]
b. 1879
12
Geraldine Murdock Bigelow
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.7.2.2]
b. 16 Apr 1879
12
Gretchen M. Bigelow
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.7.2.3]
b. 1880 [
=>
]
10
Harriet E. Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.8]
b. 6 Feb 1821 d. 30 Nov 1904
David Franum Wood
b. 16 Feb 1818 d. 4 Feb 1896
11
Arthur Eugene Wood
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.8.1]
b. 20 Jan 1844 d. 20 Apr 1920
Clara Hubbard Wood
b. Dec 1848
12
Alice Marion Wood
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.8.1.1]
b. 20 Nov 1872 d. 16 Sep 1897
11
Hattie Esther Wood
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.8.2]
b. 5 Aug 1855
Walter M Farwell
b. 1852 d. 13 Apr 1910
12
Laurence Wood Farwell
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.8.2.1]
b. 14 Sep 1885 d. Jan 1965
10
Chapin Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.9]
b. 20 Jun 1823 d. 17 Sep 1882
Julia A Smith
b. 1824 d. 21 Jun 1909
11
Luther Oscar Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.9.1]
b. 6 Oct 1848 d. 1 Nov 1904
Harriet Flora Huntress
b. 13 Nov 1850 d. 14 Mar 1935
12
Minnie Uranah Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.9.1.1]
b. 8 Aug 1872 d. 22 Sep 1872
12
Oscar Eugene Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.9.1.2]
b. 7 Jul 1876 d. 24 Jan 1912 [
=>
]
12
Walter Ernest Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.9.1.3]
b. 16 Jan 1879 d. 1 Feb 1896
12
Alice Evaline Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.9.1.4]
b. 10 Jul 1881 d. 12 Jun 1923 [
=>
]
12
George Luther Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.9.1.5]
b. 21 Mar 1887
12
Arthur Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.9.1.6]
b. 18 Jul 1889
11
Loren Nelson Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.9.2]
b. 3 Jul 1850 d. 11 May 1923
Eda Annella Robinson
b. 10 Aug 1862 d. 1932
12
Morton I Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.9.2.1]
b. 12 Nov 1889 d. 20 Mar 1933
11
Eldoras Filasker Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.9.3]
b. 18 Jun 1852
Jane Maxwell
b. Dec 1852 d. 3 Nov 1935
12
Minnie Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.9.3.1]
b. 13 Aug 1875 d. 12 Feb 1946 [
=>
]
12
William Henry Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.9.3.2]
b. 29 Oct 1877
11
William Fuller Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.9.4]
b. 19 Jun 1855 d. 26 Nov 1924
Maria Sophia Giles
b. 13 Jul 1857 d. 9 Nov 1940
12
Lilla Gertrude Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.9.4.1]
b. 20 Jun 1883 d. 24 Jan 1951 [
=>
]
12
Ada Emma Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.9.4.2]
b. 29 Nov 1885 d. 2 Jan 1950 [
=>
]
12
Cora May Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.9.4.3]
b. 7 Feb 1889 d. 1959
12
Mamie Giles Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.9.4.4]
b. 6 May 1892 d. 2 Apr 1896
11
Emma E Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.9.5]
b. 30 May 1857 d. 23 Jul 1913
Albertus D Matthewson
b. 29 Nov 1850 d. 19 Mar 1911
12
Frederick E Mathewson
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.9.5.1]
b. 23 Nov 1874
Aaron William Mason
b. 15 Aug 1847 d. 19 Mar 1904
12
William C Mason
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.9.5.2]
b. 14 Jul 1895 d. 16 Jul 1895
10
Mary Ann Murdock
[1.1.1.1.1.4.2.2.7.10]
b. 18 Jun 1825 d. 27 Aug 1834
9
Moses Taft
[1.1.1.1.1.4.2.2.8]
b. 14 Jul 1788 d. 26 Jun 1810
9
Abigail Taft
[1.1.1.1.1.4.2.2.9]
b. 24 Jan 1791 d. 15 May 1837
Chandler Taft
b. 29 May 1792
10
Augustine Calvin Taft
[1.1.1.1.1.4.2.2.9.1]
b. 11 May 1817
Deborah Millett Taylor
11
Alice Bradford Taft
[1.1.1.1.1.4.2.2.9.1.1]
b. 26 Oct 1841
11
Edward A Taft
[1.1.1.1.1.4.2.2.9.1.2]
b. 8 Apr 1845
8
Ruth Taft
[1.1.1.1.1.4.2.3]
b. 19 Feb 1740 d. 27 Jun 1797
8
Moses Taft
[1.1.1.1.1.4.2.4]
b. 21 Dec 1742
8
Margaret Taft
[1.1.1.1.1.4.2.5]
b. 19 Feb 1743 d. 3 Oct 1761
8
Nahum Taft
[1.1.1.1.1.4.2.6]
b. 17 Aug 1745
8
Priscilla Taft
[1.1.1.1.1.4.2.7]
b. 30 Apr 1749 d. 12 Sep 1833
Timothy Taft
b. 3 Apr 1750 d. 30 Nov 1808
9
Marcy Taft
[1.1.1.1.1.4.2.7.1]
b. 28 Sep 1771 d. 1 Aug 1848
+
Ezekiah Preston
b. Abt 1771
9
Josiah Taft
[1.1.1.1.1.4.2.7.2]
b. 3 May 1774
9
Abigail Taft
[1.1.1.1.1.4.2.7.3]
b. 14 Jan 1777 d. 17 Dec 1832
Moses Stone
b. 2 Mar 1775 d. 10 May 1803
10
Jonas Stone
[1.1.1.1.1.4.2.7.3.1]
b. 6 Jun 1795 d. 30 Sep 1795
10
Sukey Stone
[1.1.1.1.1.4.2.7.3.2]
b. 19 Feb 1798
9
Polly Taft
[1.1.1.1.1.4.2.7.4]
b. 1779 d. 5 Sep 1785
9
Timothy Taft
[1.1.1.1.1.4.2.7.5]
b. 1782 d. 5 Jan 1818
Mary "Polly" Reidel
b. 8 Feb 1784 d. 8 Feb 1863
10
Timothy Clark Taft
[1.1.1.1.1.4.2.7.5.1]
b. 21 Jul 1800 d. 11 May 1872
Mary A Hitchcock
b. 4 Jan 1802 d. 26 Oct 1842
11
Samuel Adams Taft
[1.1.1.1.1.4.2.7.5.1.1]
b. 11 Mar 1830 d. 5 Feb 1916
Jennie M Holt
b. 1841 d. 10 Feb 1882
12
Emma Julia Taft
[1.1.1.1.1.4.2.7.5.1.1.1]
b. 19 Jun 1865 d. 15 Jun 1929 [
=>
]
11
Elizabeth C Taft
[1.1.1.1.1.4.2.7.5.1.2]
b. 6 Jun 1834 d. 13 Dec 1915
Franklin E Hall
b. 15 Sep 1829 d. 3 Jun 1907
12
Elizabeth C Hall
[1.1.1.1.1.4.2.7.5.1.2.1]
b. 8 Jan 1855 [
=>
]
12
Frank Erwin Hall
[1.1.1.1.1.4.2.7.5.1.2.2]
b. 6 Dec 1861 d. 26 Dec 1943 [
=>
]
12
Edith Mabel Hall
[1.1.1.1.1.4.2.7.5.1.2.3]
b. 13 Apr 1870 d. 2 Aug 1952 [
=>
]
12
Gertrude Susan Hall
[1.1.1.1.1.4.2.7.5.1.2.4]
b. 26 Apr 1872 d. 6 Dec 1918 [
=>
]
10
Adolphus Taft
[1.1.1.1.1.4.2.7.5.2]
b. Abt 1804
10
Harry Taft
[1.1.1.1.1.4.2.7.5.3]
b. Abt 1806
10
Ezekiel Preston Taft
[1.1.1.1.1.4.2.7.5.4]
b. Abt 1807
10
Washington Taft
[1.1.1.1.1.4.2.7.5.5]
b. Abt 1808 d. Abt 1823
10
Charlotte Clark Taft
[1.1.1.1.1.4.2.7.5.6]
b. Abt 1810
+
Hyman Sage
b. Abt 1810
10
Christine Taft
[1.1.1.1.1.4.2.7.5.7]
b. 1811 d. 8 Jul 1847
+
George Heath
b. Abt 1811
10
Jacob R Taft
[1.1.1.1.1.4.2.7.5.8]
b. 29 Oct 1814 d. 1 Jan 1875
+
Caroline Cowles
b. 10 Jun 1817 d. 25 Jun 1875
9
Joseph Taft
[1.1.1.1.1.4.2.7.6]
b. 1784
9
Jonas Taft
[1.1.1.1.1.4.2.7.7]
b. 1786
9
Polly Taft
[1.1.1.1.1.4.2.7.8]
b. 1788 d. 1859
8
Joseph Taft
[1.1.1.1.1.4.2.8]
b. 6 Jul 1751 d. 2 Jul 1828
Hannah Keith
b. 17 Jul 1753 d. 2 Apr 1842
9
Oliver Taft
[1.1.1.1.1.4.2.8.1]
b. 6 Nov 1771 d. 20 Feb 1853
Chloe
b. 1782 d. 24 Nov 1841
10
Olive Taft
[1.1.1.1.1.4.2.8.1.1]
b. 1 Mar 1806 d. 27 Jan 1867
10
Amariah Taft
[1.1.1.1.1.4.2.8.1.2]
b. 19 Sep 1807 d. 28 Aug 1873
Mary Richards
b. Abt 1819 d. 22 Apr 1875
11
Ophelia Adams Taft
[1.1.1.1.1.4.2.8.1.2.1]
b. 23 Jan 1841
David Ruggles Edgarton
b. 1827
12
Florence Elizabeth Edgarton
[1.1.1.1.1.4.2.8.1.2.1.1]
b. 25 Jan 1867 [
=>
]
12
Mary Lelia Edgarton
[1.1.1.1.1.4.2.8.1.2.1.2]
b. 15 Apr 1868
11
Mary Elizabeth Taft
[1.1.1.1.1.4.2.8.1.2.2]
b. 23 May 1843 d. 8 Apr 1845
11
Francis Amariel Taft
[1.1.1.1.1.4.2.8.1.2.3]
b. 18 Sep 1847 d. 28 Jul 1848
10
Oliver Taft
[1.1.1.1.1.4.2.8.1.3]
b. 16 Jun 1812 d. 25 Mar 1876
Sarah Richardson
b. 1821
11
Horace H Taft
[1.1.1.1.1.4.2.8.1.3.1]
b. 1846 d. 11 May 1863
11
Jennis Isadora Taft
[1.1.1.1.1.4.2.8.1.3.2]
b. 12 Apr 1857 d. 21 Aug 1863
10
Maryan Taft
[1.1.1.1.1.4.2.8.1.4]
b. 9 Jul 1814
Hosea Aldrich
b. 14 Mar 1803
11
Chloe M Aldrich
[1.1.1.1.1.4.2.8.1.4.1]
b. 17 Jan 1838
11
Watee E Aldrich
[1.1.1.1.1.4.2.8.1.4.2]
b. 1 Sep 1840
11
Sylvia Ann Aldrich
[1.1.1.1.1.4.2.8.1.4.3]
b. 20 Jul 1844
10
George Washington Taft
[1.1.1.1.1.4.2.8.1.5]
b. 13 May 1823
Laura Ann M Taft
b. 26 Jun 1824 d. 26 May 1855
10
Laura Ann Maria Taft
[1.1.1.1.1.4.2.8.1.6]
b. 7 Jul 1844
10
Son Taft
[1.1.1.1.1.4.2.8.1.7]
b. 7 Jul 1844 d. 21 Jul 1844
10
Joseph K Taft
[1.1.1.1.1.4.2.8.1.8]
b. 25 Sep 1846 d. Jul 1868
10
Chloe Jane Taft
[1.1.1.1.1.4.2.8.1.9]
b. 25 Nov 1849
9
Huldah Taft
[1.1.1.1.1.4.2.8.2]
b. 17 Feb 1775 d. Bef 21 May 1780
9
Huldah Taft
[1.1.1.1.1.4.2.8.3]
b. 21 May 1780 d. 11 Oct 1811
Parker Tyler
b. 14 Nov 1790 d. 28 Jun 1853
10
Huldah Tyler
[1.1.1.1.1.4.2.8.3.1]
b. 4 Oct 1811
Matthew Borland
b. Abt 1800
11
Huldah J Borland
[1.1.1.1.1.4.2.8.3.1.1]
b. 28 Sep 1831 d. 10 Nov 1907
Henry Nichols
b. 31 Aug 1824
12
Edwin O Nichols
[1.1.1.1.1.4.2.8.3.1.1.1]
b. 3 May 1856 [
=>
]
12
George R Nichols
[1.1.1.1.1.4.2.8.3.1.1.2]
b. 7 Feb 1860 d. 25 Jun 1913
12
Edith Ellen Nichols
[1.1.1.1.1.4.2.8.3.1.1.3]
b. 18 Dec 1866 d. 6 Dec 1948 [
=>
]
11
Margaret Borland
[1.1.1.1.1.4.2.8.3.1.2]
b. 13 Apr 1836 d. 21 Oct 1882
John Vaughn
b. 29 Jan 1833 d. 22 Feb 1905
12
Martha Anna Vaughn
[1.1.1.1.1.4.2.8.3.1.2.1]
b. 20 May 1861 d. 6 Nov 1897
12
Samuel Ellsworth Vaughn
[1.1.1.1.1.4.2.8.3.1.2.2]
b. 31 May 1863 d. 10 Oct 1866
12
Charles Leslie Vaughn
[1.1.1.1.1.4.2.8.3.1.2.3]
b. 6 Jan 1866 d. 26 Apr 1922 [
=>
]
12
Rosalie Vaughn
[1.1.1.1.1.4.2.8.3.1.2.4]
b. 22 Feb 1870 d. 2 Jan 1939
12
Mary Isabelle Vaughn
[1.1.1.1.1.4.2.8.3.1.2.5]
b. 24 Aug 1873 d. 7 May 1952
11
Samuel Borland
[1.1.1.1.1.4.2.8.3.1.3]
b. Abt 1841
11
John P Borland
[1.1.1.1.1.4.2.8.3.1.4]
b. Abt 1849
10
Hannah Tyler
[1.1.1.1.1.4.2.8.3.2]
b. 4 Oct 1811 d. 18 Oct 1811
10
Martha Almira Tyler
[1.1.1.1.1.4.2.8.3.3]
b. 28 Sep 1830 d. 16 Oct 1909
William S Jones
b. 26 Sep 1827 d. 26 Sep 1907
11
Anna Almira Jones
[1.1.1.1.1.4.2.8.3.3.1]
b. 16 Jun 1850 d. 2 May 1922
Thomas Lyon Mix
b. 27 Jul 1848 d. 20 Jun 1936
12
Bessie Mix
[1.1.1.1.1.4.2.8.3.3.1.1]
b. 27 Nov 1873 d. 28 Jun 1888
12
Bertha Ann Mix
[1.1.1.1.1.4.2.8.3.3.1.2]
b. 15 Aug 1875 d. 20 Jul 1955 [
=>
]
12
Alpha William Mix
[1.1.1.1.1.4.2.8.3.3.1.3]
b. 1 Mar 1877 d. 7 Jan 1905
12
Rufus Hayes Mix
[1.1.1.1.1.4.2.8.3.3.1.4]
b. 22 Sep 1878 d. 3 Oct 1970 [
=>
]
12
Effie Sophia Mix
[1.1.1.1.1.4.2.8.3.3.1.5]
b. 24 Aug 1880 d. 9 Jan 1974 [
=>
]
12
Raymond Lyon Mix
[1.1.1.1.1.4.2.8.3.3.1.6]
b. 28 Apr 1882 d. 19 Dec 1973
12
George W Mix
[1.1.1.1.1.4.2.8.3.3.1.7]
b. 22 Jul 1884 d. 1 Jan 1949
12
Benjamin Harrison Mix
[1.1.1.1.1.4.2.8.3.3.1.8]
b. 14 Aug 1887 d. 6 Dec 1964 [
=>
]
12
Dora Mix
[1.1.1.1.1.4.2.8.3.3.1.9]
b. 21 Jul 1891 d. 6 Aug 1891
11
Wilber Jones
[1.1.1.1.1.4.2.8.3.3.2]
b. 1852
11
Albert J Jones
[1.1.1.1.1.4.2.8.3.3.3]
b. 10 Jun 1857 d. 17 Jun 1937
Minnie Bell Smith
b. 1863 d. Aug 1911
12
Zell Marjane Jones
[1.1.1.1.1.4.2.8.3.3.3.1]
b. 14 Jun 1892
12
Doris L Jones
[1.1.1.1.1.4.2.8.3.3.3.2]
b. Mar 1896
+
Hancie P Naylor
b. 10 Jun 1863 d. 23 Sep 1943
11
Eva Jones
[1.1.1.1.1.4.2.8.3.3.4]
b. 29 May 1861 d. 13 Aug 1924
+
William Manning Harned
b. 1857
11
Wilbur Sherman Jones
[1.1.1.1.1.4.2.8.3.3.5]
b. 17 Oct 1865 d. 1942
+
Mary Elizabeth Brown
b. 1863
9
Hannah Taft
[1.1.1.1.1.4.2.8.4]
b. 29 Sep 1783
9
Peter Taft
[1.1.1.1.1.4.2.8.5]
b. 24 Apr 1786
8
Luke Taft
[1.1.1.1.1.4.2.9]
b. 10 Aug 1754
8
Joanna Taft
[1.1.1.1.1.4.2.10]
b. 26 Jun 1756 d. 30 Sep 1761
8
Josiah Taft
[1.1.1.1.1.4.2.11]
b. 1 Oct 1758 d. 29 Sep 1761
7
Peter Rawson Taft
[1.1.1.1.1.4.3]
b. 1715 d. 12 Dec 1783
Elizabeth Cheney
b. 21 Sep 1707 d. 21 Sep 1783
8
Henry Taft
[1.1.1.1.1.4.3.1]
b. 7 Feb 1737 d. 2 Feb 1812
Sarah Howe
b. 14 Apr 1742 d. 26 Jun 1789
9
Joel Taft
[1.1.1.1.1.4.3.1.1]
b. 7 Nov 1763 d. 10 Oct 1855
Polly Earle
b. 28 Mar 1774 d. 1864
10
Martha Taft
[1.1.1.1.1.4.3.1.1.1]
b. 24 Dec 1802 d. Bef 1860
10
Emons Taft
[1.1.1.1.1.4.3.1.1.2]
b. 7 Apr 1804
10
Lewis Taft
[1.1.1.1.1.4.3.1.1.3]
b. 1814 d. Bef 1860
Mary Ann Stone
b. 22 Mar 1818 d. 27 Feb 1899
11
Fayette L Taft
[1.1.1.1.1.4.3.1.1.3.1]
b. Abt 1843
11
Hannah Taft
[1.1.1.1.1.4.3.1.1.3.2]
b. Abt 1845
10
Rufus Taft
[1.1.1.1.1.4.3.1.1.4]
b. 18 Mar 1817 d. Bef 1860
10
Roxana Taft
[1.1.1.1.1.4.3.1.1.5]
b. 14 Dec 1819 d. Bef 1860
9
Peter Taft
[1.1.1.1.1.4.3.1.2]
b. 11 Jan 1773
Phebe Wheaton
b. 28 May 1771
10
Phebe Taft
[1.1.1.1.1.4.3.1.2.1]
b. 15 Jan 1809 d. 12 Mar 1849
Cyrus Hodges
b. 1 Apr 1803 d. 1 Mar 1873
11
Adonijah White Hodges
[1.1.1.1.1.4.3.1.2.1.1]
b. 9 Aug 1827 d. 18 Apr 1828
11
Henry Francisco Hodges
[1.1.1.1.1.4.3.1.2.1.2]
b. 20 Oct 1828
11
Harry Sylvanies Hodges
[1.1.1.1.1.4.3.1.2.1.3]
b. 20 Oct 1828 d. 20 Nov 1828
11
Seth Blowers Hodges
[1.1.1.1.1.4.3.1.2.1.4]
b. 18 Mar 1831 d. 20 May 1907
Louisa Messenger
b. 19 Aug 1840 d. 30 Jan 1915
12
Phebe H Hodges
[1.1.1.1.1.4.3.1.2.1.4.1]
b. 9 Feb 1859 d. 23 Jun 1939 [
=>
]
12
Permelia Hodges
[1.1.1.1.1.4.3.1.2.1.4.2]
b. 2 Aug 1860 d. 3 Feb 1954
12
Fred Hodges
[1.1.1.1.1.4.3.1.2.1.4.3]
b. 31 Oct 1862 d. 1 Nov 1862
12
Frank Hodges
[1.1.1.1.1.4.3.1.2.1.4.4]
b. 1863
12
Cora Hodges
[1.1.1.1.1.4.3.1.2.1.4.5]
b. 19 Nov 1864 d. 9 May 1953 [
=>
]
12
Ettie Hodges
[1.1.1.1.1.4.3.1.2.1.4.6]
b. 31 Jul 1867 d. 6 Jun 1959 [
=>
]
12
Jesse Hodges
[1.1.1.1.1.4.3.1.2.1.4.7]
b. 21 Oct 1869 d. 18 Nov 1950 [
=>
]
12
Cyrus Hodges
[1.1.1.1.1.4.3.1.2.1.4.8]
b. 28 Dec 1872 d. 17 May 1954 [
=>
]
12
Seth Burt Hodges
[1.1.1.1.1.4.3.1.2.1.4.9]
b. 23 Jan 1880 d. 18 Apr 1946
12
Katherine Ellen Hodges
[1.1.1.1.1.4.3.1.2.1.4.10]
b. 12 Dec 1877 d. 10 Nov 1965 [
=>
]
12
Lois Finette Hodges
[1.1.1.1.1.4.3.1.2.1.4.11]
b. 1 May 1882 d. 25 Sep 1939 [
=>
]
11
George Luther Hodges
[1.1.1.1.1.4.3.1.2.1.5]
b. 6 Aug 1833 d. 14 Sep 1833
11
Orlin Chapman Hodges
[1.1.1.1.1.4.3.1.2.1.6]
b. 28 Aug 1835 d. 19 May 1836
11
Amos Van Buren Hodges
[1.1.1.1.1.4.3.1.2.1.7]
b. 25 Apr 1838 d. 1 Nov 1849
11
Phebe Alice Hodges
[1.1.1.1.1.4.3.1.2.1.8]
b. 2 Oct 1840 d. 11 Nov 1849
11
Sarah Salina Hodges
[1.1.1.1.1.4.3.1.2.1.9]
b. 14 Dec 1842 d. 18 Nov 1849
11
June Hodges
[1.1.1.1.1.4.3.1.2.1.10]
b. 7 Jul 1846 d. 15 Jul 1846
11
John Hodges
[1.1.1.1.1.4.3.1.2.1.11]
b. 7 Jul 1846 d. 19 Jul 1846
9
Lydia Taft
[1.1.1.1.1.4.3.1.3]
b. 15 Oct 1766 d. 28 Jul 1786
9
Amos Taft
[1.1.1.1.1.4.3.1.4]
b. 26 Aug 1768 d. 6 Aug 1789
9
Sarah Taft
[1.1.1.1.1.4.3.1.5]
b. 18 Jan 1771 d. 22 Feb 1792
9
Caleb Taft
[1.1.1.1.1.4.3.1.6]
b. 2 Apr 1775 d. 26 Oct 1840
Lois Carleton
b. Abt 1776
10
Lois Taft
[1.1.1.1.1.4.3.1.6.1]
b. 10 Mar 1801
10
Rhoda Taft
[1.1.1.1.1.4.3.1.6.2]
b. 20 Oct 1802
10
Calvin Taft
[1.1.1.1.1.4.3.1.6.3]
b. 11 Dec 1804
10
Lydia Taft
[1.1.1.1.1.4.3.1.6.4]
b. 30 Apr 1806
10
Nancy Taft
[1.1.1.1.1.4.3.1.6.5]
b. 19 Sep 1809
10
Dudley Taft
[1.1.1.1.1.4.3.1.6.6]
b. 6 Nov 1811
Calista Anne Dodge
b. 14 Nov 1817
11
George Taft
[1.1.1.1.1.4.3.1.6.6.1]
b. Abt 1841
11
Helen Taft
[1.1.1.1.1.4.3.1.6.6.2]
b. Abt 1844
11
Elbridge Taft
[1.1.1.1.1.4.3.1.6.6.3]
b. Abt 1847
Hattie Carr
b. Abt 1850
12
Carrie Calista Taft
[1.1.1.1.1.4.3.1.6.6.3.1]
b. 3 Jun 1879
11
John E. Taft
[1.1.1.1.1.4.3.1.6.6.4]
b. Abt 1849
11
Henry Edgar Taft
[1.1.1.1.1.4.3.1.6.6.5]
b. 12 Apr 1856 d. 7 Sep 1927
Nettie Buchanan
b. Abt 1856
12
Mary E. Taft
[1.1.1.1.1.4.3.1.6.6.5.1]
b. Abt 1875
12
Roselie Taft
[1.1.1.1.1.4.3.1.6.6.5.2]
b. Abt 1877
Margaret Mathilda McLean
b. 15 Apr 1870 d. 15 May 1946
12
Ettie Taft
[1.1.1.1.1.4.3.1.6.6.5.3]
b. Oct 1899
12
Leola Taft
[1.1.1.1.1.4.3.1.6.6.5.4]
b. 24 Oct 1899
10
Daniel Taft
[1.1.1.1.1.4.3.1.6.7]
b. 21 Dec 1815
9
Abisha Taft
[1.1.1.1.1.4.3.1.7]
b. 15 Jun 1777
Mary Bliss
d. 1 Feb 1822
10
Tryphina Taft
[1.1.1.1.1.4.3.1.7.1]
b. 29 Jun 1810 d. 13 Oct 1849
10
Clarissa Taft
[1.1.1.1.1.4.3.1.7.2]
b. 1817 d. 24 Dec 1840
10
Denison Taft
[1.1.1.1.1.4.3.1.7.3]
b. 6 Jun 1819
Louisa Mary Gale
b. 5 Oct 1818 d. 15 Jun 1853
11
John A Taft
[1.1.1.1.1.4.3.1.7.3.1]
b. 8 Jul 1845
11
Clara L Taft
[1.1.1.1.1.4.3.1.7.3.2]
b. 24 Feb 1847 d. Jan 1867
11
Lucius D Taft
[1.1.1.1.1.4.3.1.7.3.3]
b. 1 Dec 1852
+
Mary Ellis
+
Sally Sprague
9
David Taft
[1.1.1.1.1.4.3.1.8]
b. 13 Aug 1779
8
Gershom Taft
[1.1.1.1.1.4.3.2]
b. 20 Oct 1739 d. 29 Apr 1813
Abigail Reed
b. 12 Dec 1736 d. 24 Feb 1816
9
Calvin Taft
[1.1.1.1.1.4.3.2.1]
b. 17 Nov 1765 d. 12 Feb 1816
Molley
b. 1755 d. 12 Feb 1847
10
Newell Taft
[1.1.1.1.1.4.3.2.1.1]
b. 13 Feb 1788
10
Benjamin Clark Taft
[1.1.1.1.1.4.3.2.1.2]
b. 17 May 1790
10
Chandler Taft
[1.1.1.1.1.4.3.2.1.3]
b. 29 May 1792
Abigail Taft
b. 24 Jan 1791 d. 15 May 1837
11
Augustine Calvin Taft
[1.1.1.1.1.4.3.2.1.3.1]
b. 11 May 1817
Deborah Millett Taylor
12
Alice Bradford Taft
[1.1.1.1.1.4.3.2.1.3.1.1]
b. 26 Oct 1841
12
Edward A Taft
[1.1.1.1.1.4.3.2.1.3.1.2]
b. 8 Apr 1845
10
Ohila Taft
[1.1.1.1.1.4.3.2.1.4]
b. 25 Mar 1796
10
Mellen Taft
[1.1.1.1.1.4.3.2.1.5]
b. 18 Oct 1799 d. 3 Jun 1839
10
Mary Taft
[1.1.1.1.1.4.3.2.1.6]
b. 25 Aug 1803 d. 20 Feb 1816
10
Eliza Taft
[1.1.1.1.1.4.3.2.1.7]
b. 20 Jun 1805
10
James Whitman Taft
[1.1.1.1.1.4.3.2.1.8]
b. 21 Jan 1809 d. 8 Aug 1834
9
Elisabeth Taft
[1.1.1.1.1.4.3.2.2]
b. 13 May 1769 d. Bef 1871
9
Cheney Taft
[1.1.1.1.1.4.3.2.3]
b. 3 May 1771 d. 27 Jun 1838
9
Ruth Taft
[1.1.1.1.1.4.3.2.4]
b. 23 Feb 1773
9
Phila Taft
[1.1.1.1.1.4.3.2.5]
b. 4 Jul 1775 d. 29 Sep 1776
9
Reed Taft
[1.1.1.1.1.4.3.2.6]
b. 13 Mar 1780
8
Peter Taft
[1.1.1.1.1.4.3.3]
b. 26 Aug 1741 d. 13 Sep 1802
+
Mercy Corpe
b. 11 Dec 1732
8
Aaron Taft
[1.1.1.1.1.4.3.4]
b. 28 May 1743 d. 26 Mar 1808
Rhoda Rawson
b. 4 Oct 1749 d. 9 Jun 1827
9
Millie Taft
[1.1.1.1.1.4.3.4.1]
b. 29 Jul 1769
Ezekiel Clark
b. 13 Apr 1766
10
Willard Boyd Clark
[1.1.1.1.1.4.3.4.1.1]
b. 18 May 1792
10
William B Clark
[1.1.1.1.1.4.3.4.1.2]
b. 15 Apr 1793 d. 27 Apr 1818
10
Lucis Clark
[1.1.1.1.1.4.3.4.1.3]
b. 4 Sep 1795
10
Lewis C Clark
[1.1.1.1.1.4.3.4.1.4]
b. 6 Sep 1795 d. 16 Jan 1831
10
Maria Clark
[1.1.1.1.1.4.3.4.1.5]
b. 12 Jul 1798
+
Jacob Bryant
10
Franklin Clark
[1.1.1.1.1.4.3.4.1.6]
b. 13 Dec 1801 d. 1 Feb 1846
10
Charles T Clark
[1.1.1.1.1.4.3.4.1.7]
b. 8 Apr 1804
9
Selina Taft
[1.1.1.1.1.4.3.4.2]
b. 20 Feb 1771 d. 22 Sep 1838
Jesse Ensign Murdock
b. 13 Sep 1762 d. 11 May 1850
10
Judson Murdock
[1.1.1.1.1.4.3.4.2.1]
b. 24 Aug 1794 d. 26 Jun 1877
Judith Brigham Murdock
b. 10 Oct 1797 d. 8 Jun 1881
11
Cornelia Maria Murdock
[1.1.1.1.1.4.3.4.2.1.1]
b. 17 Dec 1817 d. 14 Dec 1882
Charles Whitman Brown
b. Jun 1812 d. 28 Feb 1864
12
Charles M. Brown
[1.1.1.1.1.4.3.4.2.1.1.1]
b. Oct 1839 d. 17 Jan 1901
12
Henry A Brown
[1.1.1.1.1.4.3.4.2.1.1.2]
b. 25 Oct 1841 d. 22 Jul 1881
12
George O. Brown
[1.1.1.1.1.4.3.4.2.1.1.3]
b. 1846
12
Cornelia Maria Brown
[1.1.1.1.1.4.3.4.2.1.1.4]
b. 9 Jan 1849 [
=>
]
12
Lizzie H. Brown
[1.1.1.1.1.4.3.4.2.1.1.5]
b. 1855
12
Emma Frances Brown
[1.1.1.1.1.4.3.4.2.1.1.6]
b. 8 Mar 1861 d. 15 Mar 1864
11
Ann L Murdock
[1.1.1.1.1.4.3.4.2.1.2]
b. 1819 d. Dec 1819
11
Louise Jane Murdock
[1.1.1.1.1.4.3.4.2.1.3]
b. 23 Jun 1823 d. 6 Jun 1841
11
Candace J Murdock
[1.1.1.1.1.4.3.4.2.1.4]
b. 1825 d. 7 Aug 1877
Timothy House
b. Abt 1815 d. Bef 1877
12
Oscar Murdock House
[1.1.1.1.1.4.3.4.2.1.4.1]
b. Jan 1861 d. 29 Jan 1867
11
Oscar Murdock
[1.1.1.1.1.4.3.4.2.1.5]
b. 24 Nov 1827 d. 7 Jun 1858
11
Harriet Elizabeth Murdock
[1.1.1.1.1.4.3.4.2.1.6]
b. 1830 d. 7 Oct 1902
+
George Partridge Sparrell
b. 7 Jun 1812 d. 26 Aug 1884
11
Henry Judson Murdock
[1.1.1.1.1.4.3.4.2.1.7]
b. 8 Dec 1831 d. 23 Mar 1899
Sarah Fisher Livermore
b. 23 Apr 1834 d. 22 Dec 1895
12
Carrie Livermore Murdock
[1.1.1.1.1.4.3.4.2.1.7.1]
b. 26 Apr 1869 [
=>
]
12
Belle Brigham Murdock
[1.1.1.1.1.4.3.4.2.1.7.2]
b. 14 Dec 1871
11
Frances Isabelle Murdock
[1.1.1.1.1.4.3.4.2.1.8]
b. 22 Nov 1833 d. 15 Dec 1918
Jason Harding Smith
b. 12 Apr 1832 d. 20 Apr 1870
12
Charles House Smith
[1.1.1.1.1.4.3.4.2.1.8.1]
b. 22 Jul 1865 d. 24 May 1920 [
=>
]
10
Harriet Fuller Murdock
[1.1.1.1.1.4.3.4.2.2]
b. 17 Nov 1798 d. 5 May 1838
Phineas Wood
b. 18 Apr 1800 d. 10 Apr 1866
11
Daughter Wood
[1.1.1.1.1.4.3.4.2.2.1]
b. 1831 d. 24 Aug 1831
11
Charles Phineas Wood
[1.1.1.1.1.4.3.4.2.2.2]
b. 3 Aug 1837 d. 30 Aug 1849
10
Selina Fuller Murdock
[1.1.1.1.1.4.3.4.2.3]
b. 24 Dec 1803 d. 19 Apr 1860
Nathaniel Whitcomb Powers
b. 23 Feb 1806 d. 16 Jul 1878
11
Selina Murdock Powers
[1.1.1.1.1.4.3.4.2.3.1]
b. 19 Mar 1846 d. 10 Aug 1932
Joseph M. Powers
b. Jul 1846 d. Bef 1920
12
Wallace C. Powers
[1.1.1.1.1.4.3.4.2.3.1.1]
b. Sep 1883
10
Eliza Taft Murdock
[1.1.1.1.1.4.3.4.2.4]
b. 8 Mar 1808 d. Bef 1812
10
Eliza Murdock
[1.1.1.1.1.4.3.4.2.5]
b. 31 Jul 1812
9
Cynthia Taft
[1.1.1.1.1.4.3.4.3]
b. 17 Aug 1773
Nathaniel Butler
b. 1769
10
Cynthia M Butler
[1.1.1.1.1.4.3.4.3.1]
b. 12 Aug 1802 d. 24 Jan 1875
10
George T Butler
[1.1.1.1.1.4.3.4.3.2]
b. 24 Nov 1804 d. 5 Nov 1841
Esther Stone
b. Abt 1806
11
Harvey Butler
[1.1.1.1.1.4.3.4.3.2.1]
b. 11 Nov 1832 d. 20 Feb 1834
11
Rawson Butler
[1.1.1.1.1.4.3.4.3.2.2]
b. 1 Dec 1834
11
Lewis Alphonse Butler
[1.1.1.1.1.4.3.4.3.2.3]
b. 5 Nov 1838
10
Rawson A Butler
[1.1.1.1.1.4.3.4.3.3]
b. 8 Jun 1806 d. 9 Sep 1865
Pamelia Mathews
b. Abt 1817
11
Henry Taft Butler
[1.1.1.1.1.4.3.4.3.3.1]
b. 20 Dec 1840 d. 24 Oct 1869
11
Mary E Butler
[1.1.1.1.1.4.3.4.3.3.2]
b. 5 Jul 1842 d. 22 Aug 1859
11
Cynthia M Butler
[1.1.1.1.1.4.3.4.3.3.3]
b. 24 May 1844
11
George M Butler
[1.1.1.1.1.4.3.4.3.3.4]
b. 10 Dec 1846
11
Edward E Butler
[1.1.1.1.1.4.3.4.3.3.5]
b. 1 May 1849
Emma Butler
b. 1853
12
Meta M Butler
[1.1.1.1.1.4.3.4.3.3.5.1]
b. 1879
11
Frank C Butler
[1.1.1.1.1.4.3.4.3.3.6]
b. 28 Jul 1852 d. 2 Dec 1859
10
Marian Butler
[1.1.1.1.1.4.3.4.3.4]
b. 19 Mar 1809
Rev Elijah Buck
b. 1 Mar 1799 d. 17 Aug 1889
11
Henry Dwight Buck
[1.1.1.1.1.4.3.4.3.4.1]
b. 7 Mar 1834
11
Cynthia Ann Buck
[1.1.1.1.1.4.3.4.3.4.2]
b. 4 Mar 1836
11
Francis Mary Buck
[1.1.1.1.1.4.3.4.3.4.3]
b. 29 Jul 1839 d. 11 Nov 1839
11
Edward Rawson Buck
[1.1.1.1.1.4.3.4.3.4.4]
b. 9 Jan 1842
11
George Nathaniel Buck
[1.1.1.1.1.4.3.4.3.4.5]
b. 15 Aug 1846
Lurella Gregory
b. Abt 1849
12
Edna Jones Buck
[1.1.1.1.1.4.3.4.3.4.5.1]
b. 15 May 1872
11
Charles Buck
[1.1.1.1.1.4.3.4.3.4.6]
b. 26 Jan 1848 d. 26 Apr 1848
11
Mary Harriett Buck
[1.1.1.1.1.4.3.4.3.4.7]
b. 18 Aug 1849
11
Charles Butler Buck
[1.1.1.1.1.4.3.4.3.4.8]
b. 23 Dec 1851
9
Polly Taft
[1.1.1.1.1.4.3.4.4]
b. 18 Sep 1777 d. 29 Aug 1816
Hezediah Murdock
b. 30 Jun 1776 d. 17 Aug 1864
10
Bazaleel White Murdock
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.1]
b. 22 Nov 1798 d. 6 Aug 1809
10
Polly Taft Murdock
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.2]
b. 28 Mar 1803 d. 26 Nov 1846
William Bond
b. 25 May 1796 d. 7 Jul 1838
11
Polly Bond
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.2.1]
b. Abt 1822
11
Laura Bond
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.2.2]
b. Abt 1824
11
Harriet Bond
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.2.3]
b. Abt 1826
11
Lucretia Bond
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.2.4]
b. 24 Jul 1826 d. 1883
Ozias Lothrop Miner
b. 15 Mar 1824 d. 1895
12
Son Miner
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.2.4.1]
b. 12 May 1857 d. 12 May 1857
12
Sylvester E Miner
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.2.4.2]
b. 3 Oct 1868
Sylvester Davis
b. 1 Dec 1824
12
Ernest Miner Davis
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.2.4.3]
b. 3 Oct 1868 d. 30 Mar 1920
11
Orvil Bond
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.2.5]
b. Abt 1830
11
Caroline Bond
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.2.6]
b. 1 Jul 1831 d. 30 Apr 1909
Samuel A Clark
d. 31 May 1889
12
Hattie Clark
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.2.6.1]
b. 27 Dec 1858 [
=>
]
11
Charles William Bond
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.2.7]
b. 17 Jun 1834
Laura Auriela Haven
b. 25 Mar 1851 d. 23 Sep 1884
12
Son Bond
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.2.7.1]
b. 4 Aug 1878 d. 4 Aug 1878
12
Daughter Bond
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.2.7.2]
b. 27 Apr 1882 d. 27 Apr 1882
11
Frances Mary Bond
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.2.8]
b. 11 Jan 1837 d. Abt 1873
Francis J Campbell
b. 9 Oct 1832 d. 30 Jun 1914
12
Guy Marchall Campbell
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.2.8.1]
b. 23 Sep 1862 [
=>
]
10
Stephen Murdock
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.3]
b. 4 Mar 1801 d. 29 Dec 1889
Eunice Dix
b. 18 Sep 1807 d. 20 Feb 1888
11
Stephen Albert Murdock
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.3.1]
b. 2 Dec 1830 d. 18 Mar 1835
11
Charles Hrney Murdock
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.3.2]
b. 30 Mar 1832 d. 18 Nov 1832
11
Eunice Elizabeth Murdock
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.3.3]
b. 8 Oct 1833 d. 3 Mar 1835
11
Albert S Murdock
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.3.4]
b. 3 Nov 1834 d. 23 Sep 1915
Lucina Hicks
b. 4 Jun 1838 d. 14 Oct 1886
12
Alta Lucina Murdock
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.3.4.1]
b. 16 Jan 1861
12
Etta Lestina Murdock
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.3.4.2]
b. 7 Jul 1862
12
George Murdock
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.3.4.3]
b. 10 Oct 1869
12
Eugene Albert Murdock
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.3.4.4]
b. 11 Jun 1874 d. 30 Jan 1911
12
Ernest Harold Murdock
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.3.4.5]
b. 8 Jul 1879
11
Edwin Frances Murdock
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.3.5]
b. 22 Aug 1836 d. 12 Dec 1837
11
Eunice Elizabeth Murdock
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.3.6]
b. 2 Jan 1840 d. 19 Oct 1882
11
Clarissa Jane Murdock
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.3.7]
b. 5 Feb 1842 d. 2 Jan 1913
11
Edwin Frances Murdock
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.3.8]
b. 9 Apr 1844
11
Henry Prescott Murdock
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.3.9]
b. 13 Jan 1846 d. 4 Jul 1892
11
Frederick Eugene Murdock
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.3.10]
b. 7 Sep 1847 d. 13 Nov 1899
11
Ella Medora Murdock
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.3.11]
b. 2 Jan 1852
10
Levi Murdock
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.4]
b. Abt 1802
10
John Murdock
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.5]
b. 2 Nov 1806 d. 8 Dec 1891
Mary Cummings
b. 7 Dec 1809 d. 17 Jun 1890
11
Martha Cummings Murdock
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.5.1]
b. 23 Aug 1841 d. 17 Jan 1873
11
John Grosvenor Murdock
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.5.2]
b. 2 Apr 1843 d. 22 Feb 1905
11
Adna Cummings Murdock
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.5.3]
b. 15 Nov 1844 d. 11 Aug 1907
10
Sylvia Murdock
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.6]
b. 28 Feb 1808 d. 23 Dec 1885
Alvin Cowles
b. Abt 1797
11
Hattie A. Cowles
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.6.1]
b. 13 Jan 1833 d. 3 Nov 1913
+
Lemuel Houghton
b. 6 Sep 1823 d. 11 Feb 1902
11
Ellen Cowles
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.6.2]
b. 1837 d. 29 Sep 1898
Harvey J Swan
b. Abt 1835 d. 1 May 1906
12
Dexter Harvey Swan
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.6.2.1]
b. 29 Apr 1863
12
Ernest A. Swan
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.6.2.2]
b. 1868 d. 18 Sep 1908
10
Grosvenor Taft Murdock
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.7]
b. 29 May 1814 d. 23 Dec 1891
+
Laura Ann Harris
10
Son Murdock
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.8]
b. 1816 d. 25 May 1816
10
Benjamin Read Murdock
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.9]
b. 20 Aug 1817 d. 20 Oct 1842
Clarinda Gilmore
b. 1815 d. 16 Sep 1905
11
William Hezekiah Murdock
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.9.1]
b. 5 May 1841 d. 10 Nov 1920
Harriet A Barber
b. 26 Aug 1843 d. 19 Nov 1885
12
Nina L Murdock
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.9.1.1]
b. 11 Nov 1871
12
Daughter Murdock
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.9.1.2]
b. 11 Nov 1871
12
Guy Clifford Murdock
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.9.1.3]
b. 26 Apr 1873
12
Lelia C Murdock
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.9.1.4]
c. 24 Oct 1867
10
Sophia Murdock
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.10]
b. 31 Aug 1819 d. 21 Oct 1889
Orin Gilmore
b. 1812 d. 26 Apr 1881
11
Kelsey Murdock Gilmore
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.10.1]
b. 29 Aug 1840 d. Abt 1909
Mary Lucina Thayer
b. 18 Sep 1840
12
George L. Gilmore
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.10.1.1]
b. 29 Mar 1865
12
Katie Sophia Gilmore
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.10.1.2]
b. 24 Jun 1869
11
A. B. Gilmore
[1.1.1.1.1.4.3.4.4.10.2]
b. 22 Aug 1843
9
Zeruiah Taft
[1.1.1.1.1.4.3.4.5]
b. 21 Nov 1779 d. 21 Oct 1852
Major Willard Lovell
b. 1782 d. 1839
10
Lucia Lovell
[1.1.1.1.1.4.3.4.5.1]
b. 19 May 1808
10
Mary Malgretta Lovell
[1.1.1.1.1.4.3.4.5.2]
b. 6 Dec 1809 d. 1857
John Foster Gilkey
b. 1803 d. 8 Aug 1878
11
Edgar H Gilkey
[1.1.1.1.1.4.3.4.5.2.1]
b. Abt 1841
11
Patrick Henry Gilkey
[1.1.1.1.1.4.3.4.5.2.2]
b. Abt 1843
Adelle F Parker
12
Harold Parker Gilkey
[1.1.1.1.1.4.3.4.5.2.2.1]
b. 23 Jul 1884
12
Mary Lovell Gilkey
[1.1.1.1.1.4.3.4.5.2.2.2]
b. 27 Jul 1875
11
Lucien Gilkey
[1.1.1.1.1.4.3.4.5.2.3]
b. Abt 1845
11
Julian F Gilkey
[1.1.1.1.1.4.3.4.5.2.4]
b. Apr 1850
10
Cynthia Ann Lovell
[1.1.1.1.1.4.3.4.5.3]
b. 29 Apr 1811 d. Bef 1861
10
Elizabeth Adeline Lovell
[1.1.1.1.1.4.3.4.5.4]
b. 4 Mar 1815 d. 29 Aug 1818
10
George Lovell
[1.1.1.1.1.4.3.4.5.5]
b. 9 Dec 1818
10
Enos Lovell
[1.1.1.1.1.4.3.4.5.6]
b. 22 Jul 1821 d. 16 Sep 1821
10
Lafayette Lovell
[1.1.1.1.1.4.3.4.5.7]
b. 27 May 1823
9
Mary Taft
[1.1.1.1.1.4.3.4.6]
b. 12 Jul 1783 d. 7 Feb 1839
+
Nathaniel Stiles
b. 22 Jun 1777 d. 1829
9
Peter Rawson Taft
[1.1.1.1.1.4.3.4.7]
b. 14 Apr 1785 d. 1 Jan 1867
Sylvia Howard
b. 1 Feb 1792 d. 1886
10
Alphonso Taft
[1.1.1.1.1.4.3.4.7.1]
b. 5 Nov 1810 d. 21 May 1891
Fannie Phelps
b. 28 Mar 1823 d. 2 Jun 1851
11
Son Taft
[1.1.1.1.1.4.3.4.7.1.1]
b. 1842 d. 1842
11
Charles P Taft
[1.1.1.1.1.4.3.4.7.1.2]
b. 21 Dec 1842 d. 21 Dec 1929
11
Peter Rawson Taft
[1.1.1.1.1.4.3.4.7.1.3]
b. 10 May 1846 d. 1888
Matilda Hulbert
b. Abt 1858
12
Hulbert Taft
[1.1.1.1.1.4.3.4.7.1.3.1]
b. 1877 d. 19 Jan 1959 [
=>
]
11
Mary Taft
[1.1.1.1.1.4.3.4.7.1.4]
b. 1848 d. 1848
11
Alphonso Taft
[1.1.1.1.1.4.3.4.7.1.5]
b. 1850 d. 1851
Louisa Maria Torrey
b. 11 Sep 1827 d. 8 Dec 1907
11
Samuel Davenport Taft
[1.1.1.1.1.4.3.4.7.1.6]
b. 7 Feb 1855 d. 1855
11
President William Howard Taft
[1.1.1.1.1.4.3.4.7.1.7]
b. 15 Sep 1857 d. 8 Mar 1930
Helen Herron
b. 2 Jan 1861 d. 22 May 1943
12
Robert Alphonso Taft
[1.1.1.1.1.4.3.4.7.1.7.1]
b. 8 Sep 1889 d. 31 Jul 1953 [
=>
]
12
Helen Herron Taft
[1.1.1.1.1.4.3.4.7.1.7.2]
b. 1 Aug 1891 d. 21 Feb 1987
12
Charles Phelps Taft
[1.1.1.1.1.4.3.4.7.1.7.3]
b. 20 Sep 1897 d. 24 Jun 1983 [
=>
]
11
Henry Waters Taft
[1.1.1.1.1.4.3.4.7.1.8]
b. 27 May 1859 d. 11 Aug 1945
Julia Wilbridge Smith
b. 9 Apr 1858
12
Walbridge Smith Taft
[1.1.1.1.1.4.3.4.7.1.8.1]
b. Abt 1884
12
Marian Taft
[1.1.1.1.1.4.3.4.7.1.8.2]
b. 1885 d. 1885
12
William Howard Taft
[1.1.1.1.1.4.3.4.7.1.8.3]
b. Abt 1886
12
Louise Taft
[1.1.1.1.1.4.3.4.7.1.8.4]
b. 20 Dec 1888 d. 1926
11
Horace Dutton Taft
[1.1.1.1.1.4.3.4.7.1.9]
b. 28 Sep 1861 d. 28 Jan 1943
+
Winifred Shepard Thompson
b. 8 Jun 1860 d. 16 Dec 1909
11
Alphonso Taft
[1.1.1.1.1.4.3.4.7.1.10]
b. 1865
11
Frances Louise Taft
[1.1.1.1.1.4.3.4.7.1.11]
b. 18 Jul 1865 d. 4 Jan 1950
+
William A Edwards
b. Abt 1861
9
Sophia Taft
[1.1.1.1.1.4.3.4.8]
b. 30 Dec 1787 d. 27 Nov 1843
9
Samuel Judson Taft
[1.1.1.1.1.4.3.4.9]
b. 6 Nov 1791 d. 9 Jun 1867
Lucy C Hayward
b. 1795 d. 21 Dec 1862
10
Sophia Amelia Taft
[1.1.1.1.1.4.3.4.9.1]
d. 12 Dec 1900
George Ropes
b. Mar 1831
11
Ella Elson Ropes
[1.1.1.1.1.4.3.4.9.1.1]
b. 1864
11
Alice Hayward Ropes
[1.1.1.1.1.4.3.4.9.1.2]
b. Feb 1866
11
George H Ropes
[1.1.1.1.1.4.3.4.9.1.3]
b. 14 Aug 1868
8
Thankful Taft
[1.1.1.1.1.4.3.5]
b. 25 May 1745 d. 26 Oct 1837
Stephen Sibley
b. 12 Jul 1741 d. 25 Aug 1828
9
Joel Sibley
[1.1.1.1.1.4.3.5.1]
b. 25 Apr 1766 d. 10 Apr 1839
Lois Louise Woods
b. 24 Jun 1767 d. 21 Nov 1832
10
Amory Sibley
[1.1.1.1.1.4.3.5.1.1]
b. 20 Jun 1792 d. 22 Jun 1849
Caroline Bosworth
b. Abt 1796 d. 13 Jan 1858
11
Martha Elmira Sibley
[1.1.1.1.1.4.3.5.1.1.1]
b. 16 Oct 1839 d. 1 Oct 1920
Harriss de Antignac
b. 7 Oct 1837 d. 22 Jan 1909
12
Caroline de Antignac
[1.1.1.1.1.4.3.5.1.1.1.1]
b. 9 Aug 1857 d. 11 Dec 1934 [
=>
]
10
Josiah Sibley
[1.1.1.1.1.4.3.5.1.2]
b. 1 Apr 1808 d. 7 Dec 1888
Sarah Ann Sophia Crapon
b. 24 Oct 1809 d. 17 May 1858
11
Samuel Hale Sibley
[1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.1]
b. 9 Sep 1835 d. 1883
Sarah Virginia Hart
b. 22 Oct 1846 d. 3 Jun 1917
12
Josiah Sibley
[1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.1.1]
b. 1866 d. 1879
12
Grace Pendleton Sibley
[1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.1.2]
b. 1868 d. 1870
12
Jennie Hart Sibley
[1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.1.3]
b. 28 Dec 1869
12
Kate Collier Sibley
[1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.1.4]
b. 1872 d. 1921
12
Samuel Hale Sibley
[1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.1.5]
b. 12 Jul 1873 d. 13 Oct 1958 [
=>
]
12
James Hart Sibley
[1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.1.6]
b. 1875
11
William Crapon Sibley
[1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.2]
b. 3 May 1832 d. 17 Apr 1902
Jane Elizabeth Thomas
b. 13 Feb 1838 d. 21 Apr 1930
12
Anne Sibley
[1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.2.1]
b. 11 Mar 1862 d. Jun 1863
12
Josiah Sibley
[1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.2.2]
b. 19 Jan 1864 d. 11 Aug 1866
12
Grigsby Thomas Sibley
[1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.2.3]
b. 21 Dec 1865 d. 1 Aug 1954 [
=>
]
12
Barney Dunbar Sibley
[1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.2.4]
b. 18 Oct 1870 d. 5 Sep 1946 [
=>
]
11
Henry Josiah Sibley
[1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.3]
b. 19 Nov 1833 d. 25 Jul 1864
11
Sophia Matilda Sibley
[1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.4]
b. 16 Oct 1837 d. 29 Oct 1897
+
Charles E Smedes
11
George Royal Sibley
[1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.5]
b. 19 Jul 1839 d. 15 Jul 1895
Emma Susan Hansel Tucker
b. 20 May 1845 d. 1911
12
Alice Reese Sibley
[1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.5.1]
b. 18 Feb 1863 [
=>
]
12
Mary Lois Sibley
[1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.5.2]
b. Feb 1870
12
Annabelle Sibley
[1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.5.3]
b. Sep 1882
12
George Royal Sibley
[1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.5.4]
b. 17 Jun 1884
11
Fannie Maria Sibley
[1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.6]
b. 13 Oct 1841 d. 20 Dec 1842
11
Mary Lois Sibley
[1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.7]
b. 3 Sep 1843 d. 23 Feb 1864
11
Alice Marie Sibley
[1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.8]
b. 9 Feb 1846 d. 13 Jul 1907
+
William T Williams
11
Robert Pendelton Sibley
[1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.9]
b. Abt 1847
Susan Wheless Bolling
b. 19 Jan 1851
12
Bolling Sibley
[1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.9.1]
b. 20 Aug 1873
12
Frances Wheless Sibley
[1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.9.2]
b. 2 Jan 1875
12
Josiah Sibley
[1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.9.3]
b. 12 May 1877 [
=>
]
12
George R Sibley
[1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.9.4]
b. 8 Feb 1879
12
Robert Sibley
[1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.9.5]
b. 28 Mar 1881
12
Herbert Sibley
[1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.9.6]
b. 13 Oct 1885 d. Aug 1904
11
Caroline Crapon Sibley
[1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.10]
b. 21 Feb 1850 d. 16 Nov 1858
11
Amory Walter Sibley
[1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.11]
b. 19 Jun 1852 d. 28 Jul 1899
11
Josiah Sibley
[1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.12]
b. 1866 d. 1879
Emaline Eve
b. 1839
11
John Adam Sibley
[1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.13]
b. 1 Sep 1861 d. 26 Mar 1934
+
Sarah Louise Chandler
11
James Longstreet Sibley
[1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.14]
b. 4 Aug 1863 d. 10 Sep 1945
Martha Erwin
b. 1862 d. 22 Dec 1930
12
Martha Erwin Sibley
[1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.14.1]
b. 13 Feb 1886 d. 10 Aug 1975 [
=>
]
12
John Adams Sibley
[1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.14.2]
b. 4 Jan 1888 d. 25 Oct 1986
12
Ulysses Erwin Maner Sibley
[1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.14.3]
b. 9 Apr 1890 d. 31 Jul 1979
12
James Longstreet Sibley
[1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.14.4]
b. 29 Aug 1891 d. 24 May 1980
12
Josephine King Sibley
[1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.14.5]
b. 13 May 1893 d. 5 May 1980
12
Mary Eve Sibley
[1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.14.6]
b. 28 Nov 1895 d. 14 Dec 1918
12
Josiah Sibley
[1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.14.7]
b. 16 Sep 1898 d. 28 Dec 1965
12
William Augustus Longstreet Sibley
[1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.14.8]
b. 12 Feb 1900 d. 1 Dec 1994
12
Marion Erwin Sibley
[1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.14.9]
b. 12 Jan 1902 d. Jun 1985
12
Alan Bowen Sibley
[1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.14.10]
b. 22 Sep 1903 d. 13 Aug 1990
11
Mary Bones Sibley
[1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.15]
b. 29 Mar 1865 d. 22 Jun 1954
11
Emma Josephine Sibley
[1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.16]
b. 23 Feb 1867 d. 25 Oct 1957
Butler King Couper
b. Abt 1851 d. 20 Oct 1913
12
Constance Maxwell Couper
[1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.16.1]
b. 1897 d. 1985
12
Butler King Couper
[1.1.1.1.1.4.3.5.1.2.16.2]
b. 1906 d. 1957
9
Lydia Sibley
[1.1.1.1.1.4.3.5.2]
b. 2 Apr 1769 d. 27 Nov 1822
Henry Staples Benson
b. 8 Aug 1770 d. 29 Jul 1821
10
Abigail Benson
[1.1.1.1.1.4.3.5.2.1]
b. 31 Mar 1795 d. 10 Nov 1821
Asa Legg
b. 7 May 1792 d. 15 Nov 1836
11
Charlotte Legg
[1.1.1.1.1.4.3.5.2.1.1]
b. 2 May 1818 d. 30 Oct 1900
George Perrier Stawitts
b. 3 Jul 1820 d. 1897
12
Jacob Stawitts
[1.1.1.1.1.4.3.5.2.1.1.1]
b. Abt 1844
12
Cornelius Stanton Stawitts
[1.1.1.1.1.4.3.5.2.1.1.2]
b. 17 Feb 1846 d. 2 May 1914 [
=>
]
12
Herbert Stawitts
[1.1.1.1.1.4.3.5.2.1.1.3]
b. Abt 1848 d. Abt 1852
12
Emma Stawitts
[1.1.1.1.1.4.3.5.2.1.1.4]
b. Abt 1850
11
Lyman Legg
[1.1.1.1.1.4.3.5.2.1.2]
b. 3 Sep 1822 d. 1 Sep 1904
Hannah Thayer
b. 11 Feb 1820
12
Enoch J Legg
[1.1.1.1.1.4.3.5.2.1.2.1]
b. 25 Sep 1846
12
Enda Isadore Legg
[1.1.1.1.1.4.3.5.2.1.2.2]
b. 25 Sep 1846 d. 1 Sep 1914
12
Sarah Thayer Legg
[1.1.1.1.1.4.3.5.2.1.2.3]
b. 20 Oct 1850
10
Harriet Benson
[1.1.1.1.1.4.3.5.2.2]
b. 14 Sep 1796 d. 22 Aug 1852
10
Mellen Benson
[1.1.1.1.1.4.3.5.2.3]
b. 14 Jan 1798
Eliza W Farnum
b. 25 Sep 1802 d. 14 Sep 1839
11
Henry Staples Benson
[1.1.1.1.1.4.3.5.2.3.1]
b. 17 May 1829
11
Almira Farnum Benson
[1.1.1.1.1.4.3.5.2.3.2]
b. 6 Aug 1830 d. 25 Dec 1835
11
James Haskins Benson
[1.1.1.1.1.4.3.5.2.3.3]
b. 16 Oct 1833
11
George Everett Benson
[1.1.1.1.1.4.3.5.2.3.4]
b. 14 Aug 1837
+
Mary Windsor Peck
b. 21 May 1798
10
Hannah Adaline Benson
[1.1.1.1.1.4.3.5.2.4]
b. 12 Aug 1802 d. 19 Jun 1822
10
Rufus Benson
[1.1.1.1.1.4.3.5.2.5]
b. 24 Jan 1804 d. 23 Aug 1805
10
Chloe Ann Benson
[1.1.1.1.1.4.3.5.2.6]
b. 23 Aug 1806
+
Dan Hill
b. 29 Nov 1796
10
Susan Augusta Benson
[1.1.1.1.1.4.3.5.2.7]
b. 9 Oct 1809 d. 25 Jul 1831
Preserved Smith Thayer
b. 9 May 1808
11
Susan Benson Thayer
[1.1.1.1.1.4.3.5.2.7.1]
b. 28 Jun 1831 d. 14 Aug 1909
+
Daniel Wheelock Aldrich
b. 28 Aug 1822 d. 23 May 1891
10
Rufus Aldrich Benson
[1.1.1.1.1.4.3.5.2.8]
b. 9 Oct 1809
+
Sarah E Buell
10
Stephen Sibley Benson
[1.1.1.1.1.4.3.5.2.9]
b. 9 Jan 1810 d. 20 Nov 1869
Elizabeth Richardson Scott
b. 8 Jan 1835 d. 20 Feb 1911
11
Jessie Harriet Benson
[1.1.1.1.1.4.3.5.2.9.1]
b. 7 Jun 1860
+
John Robert Forbes Love
b. 22 Jun 1856
11
Fred Mellen Benson
[1.1.1.1.1.4.3.5.2.9.2]
b. 10 Nov 1862 d. 9 May 1864
11
Susie Adeline Benson
[1.1.1.1.1.4.3.5.2.9.3]
b. 6 Aug 1865
8
Joel Taft
[1.1.1.1.1.4.3.6]
b. 28 May 1747 d. 27 Sep 1758
7
Sarah Taft
[1.1.1.1.1.4.4]
b. 9 Mar 1719
7
Captain Joseph Taft
[1.1.1.1.1.4.5]
b. 19 Apr 1722 d. 25 Dec 1787
Elizabeth Thayer
b. 13 Feb 1724 d. 27 Aug 1797
8
Rueben Taft
[1.1.1.1.1.4.5.1]
b. 21 Oct 1742 d. Aft 1761
Faithful Thayer
b. 18 Jun 1744 d. 1827
9
Susannah Taft
[1.1.1.1.1.4.5.1.1]
b. 27 Dec 1761 d. 14 Nov 1825
Isaac Dresser
b. 22 Feb 1759 d. 4 Dec 1835
10
Reuben Dresser
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.1]
b. 11 Jun 1781 d. 5 Sep 1782
10
Betsey Dresser
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.2]
b. 22 May 1783
10
Polly Dresser
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.3]
b. 14 Jun 1785
10
Leonard Dresser
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.4]
b. 7 Aug 1787 d. 26 Apr 1838
Mary Thombs
b. 25 Dec 1790 d. 27 Aug 1866
11
Clarissa Codelia Dresser
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.4.1]
b. 8 Nov 1812
11
Joseph Western Dresser
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.4.2]
b. 7 Jun 1814
11
Leonard Augustus Dresser
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.4.3]
b. 1 Dec 1815 d. 27 Jun 1875
Nancy Garter
b. 27 Jun 1817 d. Nov 1888
12
Mary Dresser
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.4.3.1]
b. 1844
12
Julene Dresser
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.4.3.2]
b. 1854
12
Frank Clifton Dresser
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.4.3.3]
b. 15 Feb 1859 d. 24 May 1907 [
=>
]
12
Orinda Dresser
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.4.3.4]
b. Abt 1861
11
Mary Diana Dresser
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.4.4]
b. 6 Dec 1817 d. 30 Nov 1833
11
Sarah Diana Dresser
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.4.5]
b. 21 Mar 1819
Stephen Cleveland Johnston
b. 17 Sep 1807
12
Martha Johnston
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.4.5.1]
b. Abt 1835
11
Emily Dresser
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.4.6]
b. 25 Dec 1821 d. 25 Dec 1900
John Jackson
b. 19 Jul 1821 d. 14 Feb 1893
12
Isadora Melina Jackson
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.4.6.1]
b. 1844 d. 1913
12
Daniel Jackson
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.4.6.2]
b. 1845 d. Bef 1865
12
Dewitt C Jackson
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.4.6.3]
b. 1846 d. 7 Jul 1914 [
=>
]
12
George Adolph Jackson
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.4.6.4]
b. 1853 d. 11 Dec 1929
12
Charles Montague Jackson
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.4.6.5]
b. 16 Jan 1859 d. 18 Apr 1936
11
James Volna Dresser
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.4.7]
b. 2 Mar 1823 d. 18 Jun 1826
11
Electa Dresser
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.4.8]
b. 18 Aug 1825
+
Peter Cordon
b. Abt 1882
11
Eliza Jane Dresser
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.4.9]
b. 30 Apr 1827
Chamberline
b. Abt 1824
12
George Chamberline
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.4.9.1]
b. Abt 1847
11
Louisa Dresser
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.4.10]
b. 27 Oct 1830 d. 8 Dec 1907
Horatio Nelson Garter
b. 1825
12
Porter Garter
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.4.10.1]
b. Mar 1853 d. 1905 [
=>
]
12
George Garter
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.4.10.2]
b. Dec 1860 [
=>
]
12
Anna B Garter
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.4.10.3]
b. Abt 1863
12
Nelson H Garter
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.4.10.4]
b. Abt 1871
11
John Quincy Dresser
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.4.11]
b. 20 Sep 1832 d. 16 Apr 1918
Frances Gertrude Martin
b. 30 Aug 1856 d. 31 Oct 1952
12
John Qunicy Dresser
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.4.11.1]
b. 19 Oct 1886 d. 4 Sep 1973
10
Clarissa Dresser
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.5]
b. 4 Sep 1789 d. 5 Aug 1867
Roderick Random Stewart
b. 25 Feb 1787 d. 12 Jul 1860
11
Isaac Newton Stewart
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.5.1]
b. 12 Oct 1814 d. 23 Apr 1883
11
Narcissa Random Stewart
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.5.2]
b. 25 Feb 1816 d. 17 Mar 1850
11
Elisha Milton Stewart
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.5.3]
b. 28 Jun 1818 d. 3 Jul 1899
Clarissa Fidelia Cone
b. Abt 1831 d. 1905
12
James W Stewart
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.5.3.1]
b. 4 Jul 1849 d. 1901 [
=>
]
12
Clara Eliza Stewart
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.5.3.2]
b. Sep 1853 [
=>
]
12
Harriet A Stewart
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.5.3.3]
b. May 1857 d. 1 Jan 1858
12
Charles David Stewart
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.5.3.4]
b. 19 Dec 1864 d. 29 Apr 1945 [
=>
]
12
Jennie Frances Stewart
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.5.3.5]
b. 10 Aug 1866 d. 30 Sep 1964 [
=>
]
11
Susannah Dresser Stewart
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.5.4]
b. 28 Jan 1820 d. 8 Jun 1889
James McCartney Allan
b. 1814 d. 1885
12
Mary Amelia Allan
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.5.4.1]
b. 17 Jul 1842 d. 19 Feb 1919 [
=>
]
12
Clara Allan
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.5.4.2]
b. 15 Mar 1845 d. 17 Sep 1917
12
Anna Louise Allan
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.5.4.3]
b. 30 Dec 1851 d. 21 Dec 1933 [
=>
]
11
Permelia Taft Stewart
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.5.5]
b. 7 Jun 1822 d. 4 Dec 1897
Stephen Tyler Hume
b. 3 May 1818 d. 21 May 1908
12
Anne Hume
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.5.5.1]
b. 22 Jun 1847 d. 4 Sep 1847
12
Hume
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.5.5.2]
b. 7 Aug 1848 d. 7 Aug 1848
12
George Hume
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.5.5.3]
b. 17 Jun 1850 d. 27 Jun 1850
12
Ella Narcissa Hume
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.5.5.4]
b. 13 Aug 1851 d. 26 Feb 1933
12
Clara Sarah Hume
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.5.5.5]
b. 31 Dec 1854 d. 21 Jul 1855
12
Stewart Stephen Hume
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.5.5.6]
b. 2 Oct 1859 d. 18 Jul 1860
11
La Fayette Stewart
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.5.6]
b. 21 Jun 1824 d. 17 Jun 1898
Amand Faxon
b. 6 Oct 1826
12
Eugene Fayette Stewart
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.5.6.1]
b. 14 Oct 1850 d. 12 Oct 1871
12
Marion Eolie Stewart
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.5.6.2]
b. 29 Jun 1852
12
Mary Narcissa Stewart
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.5.6.3]
b. 12 Aug 1854 d. 4 Sep 1855
12
Isabel Roxanna Stewart
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.5.6.4]
b. 2 Sep 1857
12
George Faxon Stewart
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.5.6.5]
b. 20 Apr 1862
11
Josiah Taft Stewart
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.5.7]
b. 6 Oct 1828 d. 1 Jan 1855
11
George Washington Stewart
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.5.8]
b. 27 Jan 1830 d. 20 Feb 1902
Sarah Fiester
b. 3 May 1850
12
Erastus Josiah Stewart
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.5.8.1]
b. 4 Jan 1855
12
Alice Permelia Stewart
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.5.8.2]
b. 13 Apr 1857 d. 10 Jul 1906 [
=>
]
Isadore Cornelia Fenner
b. 13 Mar 1848 d. 23 Apr 1924
12
Ida Stewart
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.5.8.3]
b. 22 Oct 1870 d. 22 Oct 1870
12
Mary May Stewart
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.5.8.4]
b. 9 Feb 1872
12
Nellie Lolita Stewart
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.5.8.5]
b. 11 May 1875
12
Albert E Stewart
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.5.8.6]
b. 3 Mar 1878
12
Minnie Isadora Stewart
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.5.8.7]
b. 1885
12
Florence Ethel Stewart
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.5.8.8]
b. 6 Jan 1888
10
Susanna Dresser
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.6]
b. 3 Nov 1791
+
Jonathan Gould
b. Abt 1788
10
Isaac Dresser
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.7]
b. 19 May 1793 d. 5 Feb 1862
Laura Frary
b. 2 Nov 1802 d. Aug 1858
11
James Munroe Dresser
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.7.1]
b. 6 Dec 1820 d. 13 Nov 1833
11
Justus Frary Dresser
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.7.2]
b. 21 Nov 1822 d. 1824
11
Justus Frary Dresser
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.7.3]
b. 7 Nov 1825 d. 1 Jan 1881
Catherine Hughes McAllister
b. 25 Apr 1829 d. 28 Mar 1850
12
Catherine Hughes Dresser
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.7.3.1]
b. 19 Mar 1850 d. 20 Feb 1851
Jane Patterson
b. 5 Apr 1830 d. 24 Apr 1859
12
James Munro Dresser
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.7.3.2]
b. 7 Jun 1854 d. 6 Jan 1879
12
Jessie Lillian Dresser
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.7.3.3]
b. 20 Feb 1856 d. 15 Mar 1878
12
Justus William Dresser
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.7.3.4]
b. 18 Aug 1857 d. 2 Oct 1933 [
=>
]
Annah Livinia Hume
b. 8 Feb 1829 d. 1 Jan 1896
12
Richard Leonard "Dick" Dresser
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.7.3.5]
b. 8 Jul 1862 d. 5 Jun 1945 [
=>
]
12
Laura Kate Dresser
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.7.3.6]
b. 19 Oct 1864 d. 24 Jul 1919
12
Annabel Dresser
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.7.3.7]
b. 20 Feb 1870 d. 29 Sep 1870
11
Theda Dresser
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.7.4]
b. 9 Sep 1827 d. 31 Oct 1895
+
P H Sniff
b. Abt 1825
11
Clarissa Susannah Dresser
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.7.5]
b. 30 Nov 1832 d. 20 Jan 1852
11
Eliza Rebecca Dresser
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.7.6]
b. 7 Feb 1841 d. 9 Sep 1843
+
Emily Marcy
b. Abt 1805
10
Diana Dresser
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.8]
b. 17 Dec 1795
10
David Dresser
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.9]
b. 12 Sep 1797
Dorcas Williams
b. 18 Apr 1794
11
Gilbert W Dresser
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.9.1]
b. Abt 1819 d. 17 Jul 1856
Ann M Dresser
b. 1822
12
Hellen M Dresser
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.9.1.1]
b. 1842
12
Gilbert W Dresser
[1.1.1.1.1.4.5.1.1.9.1.2]
b. 1845
9
Nancy Taft
[1.1.1.1.1.4.5.1.2]
b. 9 Jul 1763 d. 1835
9
Rhoxanna Taft
[1.1.1.1.1.4.5.1.3]
b. 14 Aug 1765 d. 1837
+
Josiah Wood
9
Diana Taft
[1.1.1.1.1.4.5.1.4]
b. 4 Sep 1767 d. 1830
+
Silvanus Thayer
b. 4 Sep 1762
9
Joseph Taft
[1.1.1.1.1.4.5.1.5]
b. 26 Jun 1769
9
Marcy Taft
[1.1.1.1.1.4.5.1.6]
b. 11 Aug 1771 d. 1840
9
Polly Taft
[1.1.1.1.1.4.5.1.7]
b. 9 Jun 1773 d. 26 Oct 1848
Jesse Hurlbut
b. 21 Jul 1769 d. 11 Jan 1848
10
Polly Hurlbut
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.1]
b. 27 Apr 1793 d. 17 Sep 1861
John William Wilcox
b. 8 Jun 1793 d. 17 Sep 1861
11
Stephen Dorman Wilcox
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.1.1]
b. Abt 1815 d. 22 Jan 1863
Nancy Jane Miller
b. 10 Jul 1811 d. 7 Apr 1905
12
Laura Wilcox
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.1.1.1]
b. 23 Dec 1830 d. Bef 1905
12
Poly Wilcox
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.1.1.2]
b. 2 Dec 1832 d. Bef 1905
12
Hariat Wilcox
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.1.1.3]
b. 2 Aug 1835 d. Bef 1905
12
Nathan C Wilcox
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.1.1.4]
b. 31 Dec 1838 d. Bef 1905 [
=>
]
12
Alma Wilcox
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.1.1.5]
b. 28 Nov 1841 d. Bef 1905
12
James King Wilcox
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.1.1.6]
b. 25 Feb 1843 d. 15 Jun 1918 [
=>
]
12
Stephen Franklin Wilcox
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.1.1.7]
b. 21 Oct 1845 d. 25 Oct 1864
12
Eleanor Jane Wilcox
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.1.1.8]
b. 26 Feb 1848 d. 23 Jun 1934 [
=>
]
12
Clarisa Marinza Wilcox
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.1.1.9]
b. 12 Apr 1855 d. 14 Apr 1925 [
=>
]
12
William T Wilcox
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.1.1.10]
b. 24 Jul 1850 d. Bef 1905
12
Nancy R Wilcox
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.1.1.11]
b. 24 Jul 1850 d. Bef 1905
12
George W Wilcox
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.1.1.12]
b. 27 Sep 1852 d. Bef 1905
12
Boy Wilcox
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.1.1.13]
b. Abt 1857
12
Margaret Wilcox
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.1.1.14]
b. 25 Jun 1859
12
Boy Wilcox
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.1.1.15]
b. Abt 1861
11
Roxana Wilcox
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.1.2]
b. Abt 1817 d. 1820
11
Montreville Russell Wilcox
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.1.3]
b. 4 Sep 1826 d. 13 Jan 1888
Susan Minerva Greenfield
b. 2 Apr 1836 d. 27 Dec 1917
12
Eva Wilcox
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.1.3.1]
b. 1858
12
John Wilcox
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.1.3.2]
b. 1860 d. 1917
12
Mary Amy Wilcox
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.1.3.3]
b. 14 Jan 1861 d. 24 Mar 1940 [
=>
]
12
Burgess Greenfield Wilcox
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.1.3.4]
b. Abt 1863 d. 3 Apr 1938 [
=>
]
12
Ovando Wilcox
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.1.3.5]
b. 1870
12
Louisa Wilcox
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.1.3.6]
b. 9 Apr 1877 d. 21 Jun 1955 [
=>
]
10
Reuben Hurlbut
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.2]
b. 7 Apr 1794 d. 28 May 1879
Hannah Moore
b. 1794 d. 18 Nov 1861
11
Diana S Hurlbut
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.2.1]
b. 12 Nov 1816
+
William Dake
11
Polly A Hurlbut
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.2.2]
b. 27 Nov 1818
+
E Dake
11
Sarah Ann Hurlburt
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.2.3]
b. 26 Jul 1820 d. 23 Apr 1908
John Wines
b. 16 Jun 1814 d. 1898
12
Sophia Misplea Wines
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.2.3.1]
b. 19 May 1847 d. 8 Nov 1848
12
Kate Alvira Wines
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.2.3.2]
b. 20 Aug 1848 d. 28 Feb 1932 [
=>
]
12
Frank Pierce Wines
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.2.3.3]
b. 6 Mar 1853 d. 16 Dec 1855
12
Frederick Barlow Wines
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.2.3.4]
b. 24 Oct 1857
11
Chauncey Hurlbut
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.2.4]
b. 7 Nov 1822
11
Marmary Annette Hurlbut
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.2.5]
b. 12 Sep 1824 d. 14 May 1914
+
J Towsley
11
Edwin Taft Monroe Hurlbut
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.2.6]
b. 20 Jun 1828
Helen Coburn
b. 18 Nov 1830
12
Clarence Romeyn Hurlbut
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.2.6.1]
b. 20 Oct 1852
12
Clara Adele Hurlbut
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.2.6.2]
b. 7 Jun 1857
11
Iantha C Hurlbut
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.2.7]
b. 31 May 1826
11
Seth Hurlbut
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.2.8]
b. 12 Jul 1833
+
Margaret Green
b. Abt 1840
11
Sylvia Hurlbut
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.2.9]
b. 7 Feb 1836
10
Aseneth Hurlbut
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3]
b. 7 Jan 1797 d. 26 May 1875
Bechias Dustin
b. 5 Oct 1793 d. 6 Nov 1874
11
David Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.1]
b. 15 Feb 1817 d. 25 Jun 1893
Mary Ann Call
b. 10 Apr 1819 d. 5 Mar 1910
12
Mary Winnifred Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.1.1]
b. 1842 [
=>
]
12
David W Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.1.2]
b. 1845 d. 2 Aug 1849
12
Ida Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.1.3]
b. Sep 1852 [
=>
]
12
Helen J. Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.1.4]
b. Abt 1858
Mary Ann Evans
b. 1818
12
Dorothy Jane Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.1.5]
b. 23 May 1845 d. 19 Feb 1903 [
=>
]
12
Ann Viola Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.1.6]
11
Fornatus Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.2]
b. 17 Feb 1820 d. 11 Oct 1872
Sonora Rosaline Call
b. 29 Dec 1826 d. 5 Mar 1906
12
Andrew Fornatus Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.2.1]
b. 23 Apr 1847 d. 6 May 1910 [
=>
]
12
Oscar Cyril Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.2.2]
b. 5 May 1849 d. 13 Mar 1908 [
=>
]
12
Charles Roscoe Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.2.3]
b. 12 Apr 1851 d. 21 Sep 1927 [
=>
]
12
Elnora Rosaline Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.2.4]
b. 16 Aug 1853 d. 22 Jun 1913 [
=>
]
12
Calista Evaline Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.2.5]
b. 14 Feb 1855 d. 25 Nov 1927 [
=>
]
12
Delbert Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.2.6]
b. 21 Dec 1857 d. 1 Oct 1864
12
Sarah Aseneth Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.2.7]
b. 7 Aug 1859 d. 9 Sep 1860
12
Arthur Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.2.8]
b. 2 Sep 1861 d. 4 Apr 1923 [
=>
]
12
Lillie Ellen Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.2.9]
b. 31 Mar 1864 d. 7 Jul 1884 [
=>
]
12
May Rosetta Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.2.10]
b. 9 Oct 1866 d. 14 May 1922 [
=>
]
12
Fannie Samantha Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.2.11]
b. 15 Apr 1869 d. 13 Mar 1923 [
=>
]
11
Bechias Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.3]
b. 21 Oct 1823 d. Aft 1870
11
Seth Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.4]
b. 21 Oct 1825 d. 2 Dec 1903
Hannah Loveland
b. 28 May 1825 d. 1867
12
Edwin Seth Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.4.1]
b. 28 May 1847 d. 20 Sep 1915
12
Hannah Sophia Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.4.2]
b. 22 Feb 1849 d. 2 Apr 1904
12
William Henry Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.4.3]
b. 28 Jun 1851 d. 1 Nov 1932
12
Chauncey Bechias Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.4.4]
b. 18 Feb 1853 d. 10 Mar 1937
12
Bechies Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.4.5]
b. 18 Feb 1853
12
Chester Moroni Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.4.6]
b. 10 Mar 1854 d. 10 Jan 1910
12
Hyrum Nephi Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.4.7]
b. 27 Oct 1855 d. 31 Jul 1931
12
James Bechias Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.4.8]
b. 24 Dec 1857 d. 6 Sep 1858
12
Nancy Maria Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.4.9]
b. 25 Nov 1859 d. 27 Nov 1859
12
Chauncey Loveland Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.4.10]
b. 27 Nov 1863 d. 4 Mar 1937
12
Levi Jerome Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.4.11]
b. 1 Apr 1865 d. 12 Apr 1930
Ann Reed Everington
b. 18 Dec 1826 d. 11 Jan 1910
12
Byrnina Ann Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.4.12]
b. 17 Jul 1872 d. 23 Sep 1951 [
=>
]
11
Joseph Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.5]
b. 15 Dec 1827 d. 10 Dec 1914
Sarah Phelps Littlefield
b. 12 Jan 1830 d. 21 Sep 1917
12
Hiram Joseph Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.5.1]
b. 11 Jan 1847 d. 3 Mar 1922 [
=>
]
12
Lavina Jane Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.5.2]
b. 31 Jul 1848 d. Abt 1918 [
=>
]
12
Asenath Cecelia Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.5.3]
b. 25 Feb 1850 d. 11 Dec 1943 [
=>
]
12
Izora Eblin Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.5.4]
b. 5 Nov 1859 d. 6 Mar 1948 [
=>
]
Mary Catherine Bickmore
b. 6 Jan 1862 d. 14 Jun 1936
12
Henry Harry Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.5.5]
b. 11 Mar 1879 d. Bef Jun 1880
12
Elizabeth Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.5.6]
b. 7 Apr 1882 d. 11 Nov 1923
12
Tina Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.5.7]
b. 28 Jan 1885 d. 21 Jun 1979
12
Truman Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.5.8]
b. 25 Nov 1885 d. 28 Oct 1886
12
Edward Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.5.9]
b. 22 Oct 1886 d. Abt Oct 1886
12
Evelyn Kathleen Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.5.10]
b. 4 Nov 1887 d. 19 May 1987 [
=>
]
12
Christopher Columbus Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.5.11]
b. 7 Jan 1889 d. 11 Jan 1962 [
=>
]
12
Benjamen Harrison Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.5.12]
b. 5 Apr 1892 d. 22 Dec 1942 [
=>
]
12
Lillie Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.5.13]
b. 5 Apr 1894 d. 27 Jan 1955 [
=>
]
12
Albert McKinley Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.5.14]
b. 9 Aug 1896 d. 6 Dec 1972 [
=>
]
12
Daisey Belle Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.5.15]
b. 9 Sep 1898 d. 12 Nov 1973 [
=>
]
11
Aseneth Cecilia Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.6]
b. 25 Feb 1829 d. Mar 1899
Isaac Allen
b. 22 Apr 1831 d. 12 Jan 1912
12
Sarah E Allen
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.6.1]
b. 26 Mar 1854 d. Bef 1912
12
Isaac Alexander Allen
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.6.2]
b. 26 Mar 1854 d. 8 Nov 1934 [
=>
]
12
James Scott Allen
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.6.3]
b. 1856 d. 15 Nov 1920
12
George Allen
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.6.4]
b. 28 Oct 1857 d. 21 Jan 1875
12
Eliza Amberzine Allen
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.6.5]
b. Abt 1860 d. 19 Aug 1943 [
=>
]
12
Emma Bell Allen
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.6.6]
b. 3 Feb 1860 d. 28 Mar 1943 [
=>
]
12
Truman W Allen
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.6.7]
b. 21 Feb 1862 d. 21 Sep 1882
12
Alice Augusta Allen
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.6.8]
b. 29 Jul 1864 d. 26 Jan 1890 [
=>
]
11
Roxanna Mahalia Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.7]
b. 3 Jul 1833 d. 11 Mar 1903
John Eller Welker
b. 16 Mar 1826 d. 1 Jun 1913
12
Roxana Louisa Welker
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.7.1]
b. 20 Aug 1851 d. 26 Jan 1918 [
=>
]
12
John Eller Welker
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.7.2]
b. 12 Jul 1853 d. 29 Nov 1918 [
=>
]
11
Franklin Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.8]
b. 1834 d. Aft 1885
11
Christopher Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.9]
b. 1837 d. 12 Aug 1898
11
Andrew Dustin
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.3.10]
d. Bef 1845
10
Diana Hurlbut
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.4]
b. 29 Mar 1798 d. 1 Mar 1841
+
George Fox
b. 1794
10
Alma Hurlbut
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.5]
b. 13 Feb 1800
+
Reed
b. Abt 1796
10
Hiram Higgins Hurlbut
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.6]
b. 29 Nov 1801 d. 20 Jul 1864
Lydia McIntyre
b. 18 Aug 1805
11
Mary Hurlbut
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.6.1]
b. 27 Jun 1826 d. 7 Jul 1865
+
Hiram Berry
11
Sarah Hurlbut
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.6.2]
b. 2 Sep 1827
+
Nicholas Youngs
11
Esther Mahala Hurlburt
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.6.3]
b. 20 Jan 1829
+
Samuel F Seeley
b. 1817
11
Jesse Hurlbut
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.6.4]
b. 13 Nov 1830 d. 25 Jul 1874
Mary Jane Richardson
b. 16 May 1841 d. 16 Oct 1909
12
Elizabeth Ester Hurlbut
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.6.4.1]
b. 7 Aug 1866 d. 4 Mar 1885
12
Emma Frances Hurlbut
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.6.4.2]
b. 1 Jul 1868 d. 21 May 1926
12
Jesse David Hurlbut
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.6.4.3]
b. 1 Jul 1871 d. 9 Nov 1962 [
=>
]
11
Matilda Hurlbut
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.6.5]
b. 7 Jun 1832
+
Taylor
11
Urilla Hurlbut
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.6.6]
b. 20 Mar 1834
11
Stephen Hulbert
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.6.7]
b. 28 Dec 1836 d. 1882
Mary Knapp
b. Abt 1840 d. 1873
12
Fred Hulbert
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.6.7.1]
b. Abt 1864
12
Hiram Frank Hulbert
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.6.7.2]
b. 1867
12
Henry Ovando Hulbert
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.6.7.3]
b. 12 Jan 1871 d. 14 Nov 1954 [
=>
]
11
Lydia Hurlbut
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.6.8]
b. 5 May 1838
11
Hiram Hurlbut
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.6.9]
b. 6 Aug 1840
11
John William Hurlbut
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.6.10]
b. 28 Feb 1843
Miranda Chase
b. Abt 1847
12
John Hurlbut
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.6.10.1]
b. 3 Mar 1873 d. 4 Feb 1926
10
Horatio Hurlbut
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.7]
b. 9 Nov 1806 d. 1890
Sabrina Lumbard
b. 1 Sep 1812
11
Vincent Lumbard Hurlbut
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.7.1]
b. 28 Jan 1829
10
Quartus Ovando Hurlbut
[1.1.1.1.1.4.5.1.7.8]
b. 7 Feb 1804 d. 10 Jan 1879
+
Hetty Dann
b. Abt 1808
9
Ruth Taft
[1.1.1.1.1.4.5.1.8]
b. 5 Jul 1778 d. 1860
William Smith
b. Abt 1779
10
Thomas Smith
[1.1.1.1.1.4.5.1.8.1]
b. Abt 1803 d. 21 Feb 1884
9
Betsy Taft
[1.1.1.1.1.4.5.1.9]
b. 24 Mar 1776 d. Feb 1853
Moses Chapin
b. 24 May 1776 d. 19 Jul 1844
10
Joseph Chapin
[1.1.1.1.1.4.5.1.9.1]
b. 15 Jul 1797 d. 12 Jun 1857
Louisa Veaux
b. Abt 1801
11
Sarah Chapin
[1.1.1.1.1.4.5.1.9.1.1]
b. 3 Dec 1825
+
Rufus Ellis Tower
b. 26 Feb 1830
11
Caroline Chapin
[1.1.1.1.1.4.5.1.9.1.2]
c. 14 Aug 1828 d. 20 Aug 1843
Harriet Elizabeth Voax
b. 18 Jul 1821 d. 23 Sep 1872
11
Joseph Chapin
[1.1.1.1.1.4.5.1.9.1.3]
b. 6 May 1845 d. 22 Aug 1846
11
Harriet Louise Chapin
[1.1.1.1.1.4.5.1.9.1.4]
b. 9 Mar 1848
11
Ann Elizabeth Chapin
[1.1.1.1.1.4.5.1.9.1.5]
b. 10 Feb 1851 d. 22 Jun 1853
10
Stephen Chapin
[1.1.1.1.1.4.5.1.9.2]
b. 4 Jan 1801 d. 9 Mar 1843
Julia Emily Taft
b. 1807
11
Moses Williams Chapin
[1.1.1.1.1.4.5.1.9.2.1]
b. 10 Jun 1829 d. 7 May 1884
Catharine Lackey
b. May 1830 d. 26 Feb 1918
12
Lucian Augustine Chapin
[1.1.1.1.1.4.5.1.9.2.1.1]
b. 1 Jul 1850 d. 5 Feb 1904 [
=>
]
12
Alice Augusta Chapin
[1.1.1.1.1.4.5.1.9.2.1.2]
b. 12 Aug 1853
12
Henry Burlingame Chapin
[1.1.1.1.1.4.5.1.9.2.1.3]
b. 3 Jun 1856 d. 23 Aug 1856
12
Julia Emily Chapin
[1.1.1.1.1.4.5.1.9.2.1.4]
b. 30 Aug 1857
10
Ruth Adaline Chapin
[1.1.1.1.1.4.5.1.9.3]
b. 24 Oct 1802 d. 1862
William Thornton
b. Abt 1798 d. 1862
11
Sylvia Taft Thornton
[1.1.1.1.1.4.5.1.9.3.1]
b. 2 Jan 1833
11
William Handy Thornton
[1.1.1.1.1.4.5.1.9.3.2]
b. 16 Jan 1837
11
John Green Thornton
[1.1.1.1.1.4.5.1.9.3.3]
b. 11 Mar 1841
10
Orris Taft Chapin
[1.1.1.1.1.4.5.1.9.4]
b. 27 Jan 1805 d. 20 Dec 1849
Martha Dickson
b. 9 Jan 1804 d. 16 Mar 1856
11
Thomas Rundle Chapin
[1.1.1.1.1.4.5.1.9.4.1]
b. 11 Oct 1829 d. 24 Feb 1905
Elizabeth Shields
b. 6 May 1865
12
Abby Chapin
[1.1.1.1.1.4.5.1.9.4.1.1]
b. 30 May 1899 d. 13 Jul 1899
11
Augustine Francis Chapin
[1.1.1.1.1.4.5.1.9.4.2]
b. 9 Jan 1832 d. 6 Jul 1868
Louisa Roland
b. 27 Mar 1839
12
Thomas Green Chapin
[1.1.1.1.1.4.5.1.9.4.2.1]
b. 22 Feb 1856
12
Rodolph Chapin
[1.1.1.1.1.4.5.1.9.4.2.2]
b. 2 Sep 1858
12
Martha Evaline Chapin
[1.1.1.1.1.4.5.1.9.4.2.3]
b. 29 Sep 1860
12
Mary Augustine Chapin
[1.1.1.1.1.4.5.1.9.4.2.4]
b. 21 Jan 1863
12
Josephine Chapin
[1.1.1.1.1.4.5.1.9.4.2.5]
b. 4 Jul 1867
11
Luthera Chapin
[1.1.1.1.1.4.5.1.9.4.3]
b. Abt 1834
10
Betsy Taft Chapin
[1.1.1.1.1.4.5.1.9.5]
b. 14 Oct 1807 d. 21 Apr 1838
Parley Gould
b. 17 Sep 1807 d. 16 Jan 1877
11
Luthera Gould
[1.1.1.1.1.4.5.1.9.5.1]
b. 15 Jul 1833 d. 13 Oct 1862
+
Charles Barton Prentice
b. 5 Apr 1836
11
Augustine Gould
[1.1.1.1.1.4.5.1.9.5.2]
b. 18 Mar 1835
Augusta Dillingham
b. Abt 1838 d. 9 Sep 1871
12
Edward E Gould
[1.1.1.1.1.4.5.1.9.5.2.1]
b. 20 Aug 1863
12
Ida S Gould
[1.1.1.1.1.4.5.1.9.5.2.2]
b. 24 Mar 1866
10
Abigail Adams Chapin
[1.1.1.1.1.4.5.1.9.6]
b. 4 Sep 1809 d. 6 Aug 1854
Benedict Arnold Greene
b. 17 Jan 1812 d. 12 Jan 1858
11
Robert E Greene
[1.1.1.1.1.4.5.1.9.6.1]
b. 2 Mar 1845
11
Julia Amanda Greene
[1.1.1.1.1.4.5.1.9.6.2]
b. 27 Feb 1847 d. Feb 1853
11
Moses Chapin Greene
[1.1.1.1.1.4.5.1.9.6.3]
b. 15 Apr 1849 d. 1849
11
Walter Ernest Greene
[1.1.1.1.1.4.5.1.9.6.4]
b. 1850
10
Diana Maria Chapin
[1.1.1.1.1.4.5.1.9.7]
b. 9 Mar 1812 d. 23 Aug 1854
Richard Waterman
b. 4 Aug 1809 d. 1883
11
Abbie Maria Waterman
[1.1.1.1.1.4.5.1.9.7.1]
b. 29 Mar 1835 d. 1906
Johnathan West
b. 17 Dec 1817 d. 6 Mar 1895
12
Nellie Maria West
[1.1.1.1.1.4.5.1.9.7.1.1]
b. 19 Apr 1862 d. 1935 [
=>
]
12
Mary Harrison West
[1.1.1.1.1.4.5.1.9.7.1.2]
b. 7 Dec 1865
12
Charles Howard West
[1.1.1.1.1.4.5.1.9.7.1.3]
b. 1873
12
Louise Chapin West
[1.1.1.1.1.4.5.1.9.7.1.4]
b. 30 May 1876 [
=>
]
11
Louisa Chapin Waterman
[1.1.1.1.1.4.5.1.9.7.2]
b. 23 Jul 1837 d. 25 Jul 1837
11
Elizabeth Slade Waterman
[1.1.1.1.1.4.5.1.9.7.3]
b. 23 Jul 1837
11
Caroline Chapin Waterman
[1.1.1.1.1.4.5.1.9.7.4]
b. 5 Dec 1844 d. 11 Mar 1848
11
John Waterman
[1.1.1.1.1.4.5.1.9.7.5]
b. 7 Mar 1847 d. 26 Feb 1918
+
Alice Augusta Chapin
b. 12 Aug 1853
+
Caroline Davis
b. Abt 1852
11
Thomas Warner Waterman
[1.1.1.1.1.4.5.1.9.7.6]
b. 8 Jun 1849
+
Caroline Davis
b. 15 Jul 1851 d. 5 Dec 1895
11
Fannie Alice Waterman
[1.1.1.1.1.4.5.1.9.7.7]
b. 24 Oct 1851 d. 21 Sep 1853
11
Frank Arthur Waterman
[1.1.1.1.1.4.5.1.9.7.8]
b. 24 Oct 1852
+
Abbie Jane Berry
10
Moses Smeadley Chapin
[1.1.1.1.1.4.5.1.9.8]
b. 15 Aug 1816 d. 14 Nov 1819
10
Adaline Chapin
[1.1.1.1.1.4.5.1.9.9]
b. 14 May 1820 d. 1904
8
Lucy Taft
[1.1.1.1.1.4.5.2]
b. 5 Mar 1745 d. 1822
8
Silas Taft
[1.1.1.1.1.4.5.3]
b. 22 Nov 1747
8
Sarah Taft
[1.1.1.1.1.4.5.4]
b. 8 Mar 1750 d. 3 May 1811
8
Asahel Taft
[1.1.1.1.1.4.5.5]
b. 30 Jul 1752 d. Nov 1826
Rachel Alton
b. 9 Mar 1760 d. 5 Aug 1851
9
Silas Taft
[1.1.1.1.1.4.5.5.1]
b. 21 Oct 1780
9
Elizabeth Taft
[1.1.1.1.1.4.5.5.2]
b. 17 Mar 1783
9
Rachel Taft
[1.1.1.1.1.4.5.5.3]
b. Abt 1785
9
Mary Taft
[1.1.1.1.1.4.5.5.4]
b. 1787
9
Asahel J Taft
[1.1.1.1.1.4.5.5.5]
b. 1792
9
Joseph Taft
[1.1.1.1.1.4.5.5.6]
b. 15 Jun 1794
9
Sarah Taft
[1.1.1.1.1.4.5.5.7]
b. 28 Feb 1797 d. 29 Sep 1879
Wheaton W Wilson
b. 5 Aug 1787 d. 13 Jan 1874
10
Wheaton Wilson
[1.1.1.1.1.4.5.5.7.1]
b. 10 Nov 1817 d. 17 Aug 1900
10
Mary Wilson
[1.1.1.1.1.4.5.5.7.2]
b. 7 Sep 1820 d. 23 Nov 1887
10
Fanny Maria Wilson
[1.1.1.1.1.4.5.5.7.3]
b. 12 Sep 1822 d. 1900
10
Alonzo Wilson
[1.1.1.1.1.4.5.5.7.4]
b. 19 Sep 1824 d. 13 Oct 1826
10
Emily Wilson
[1.1.1.1.1.4.5.5.7.5]
b. 7 May 1827
10
Sophia Wilson
[1.1.1.1.1.4.5.5.7.6]
b. 19 Jul 1829 d. 9 Apr 1919
10
Caroline Louisa Wilson
[1.1.1.1.1.4.5.5.7.7]
b. 4 Mar 1832 d. 11 Mar 1892
10
John Wilson
[1.1.1.1.1.4.5.5.7.8]
b. 26 May 1834
10
William Walter Wilson
[1.1.1.1.1.4.5.5.7.9]
b. 8 Sep 1836 d. 31 Jul 1839
10
Wallace Warren Wilson
[1.1.1.1.1.4.5.5.7.10]
b. 28 Sep 1839 d. 22 Oct 1906
Sarah A Samson
b. 6 Dec 1842 d. 30 Apr 1915
11
Clarence Wallace Wilson
[1.1.1.1.1.4.5.5.7.10.1]
b. Jul 1861 d. 7 Feb 1904
Lizzie Mary Knapp
b. 24 Dec 1862 d. 1900
12
Stella M Wilson
[1.1.1.1.1.4.5.5.7.10.1.1]
b. 27 Jul 1883 d. 1903
11
Mable Wilson
[1.1.1.1.1.4.5.5.7.10.2]
b. 17 Mar 1865 d. 31 Mar 1873
11
William A Wilson
[1.1.1.1.1.4.5.5.7.10.3]
b. 2 Jul 1866 d. 21 Nov 1904
Nellie C Barrett
b. Jun 1868
12
Arthur William Wilson
[1.1.1.1.1.4.5.5.7.10.3.1]
b. 15 Jun 1891 d. 1 Sep 1961
12
Sarah Alberta Wilson
[1.1.1.1.1.4.5.5.7.10.3.2]
b. 17 Feb 1893 d. 1 May 1960 [
=>
]
12
Harold Elton Wilson
[1.1.1.1.1.4.5.5.7.10.3.3]
b. 21 Mar 1895 d. 6 Nov 1961
12
Lawrence Wilmer Wilson
[1.1.1.1.1.4.5.5.7.10.3.4]
b. 3 Aug 1896 d. 1 May 1964 [
=>
]
12
Florence Wilson
[1.1.1.1.1.4.5.5.7.10.3.5]
b. Aug 1897
11
Albert Wilson
[1.1.1.1.1.4.5.5.7.10.4]
b. 1870
11
Walter Gordon Wilson
[1.1.1.1.1.4.5.5.7.10.5]
b. 20 Dec 1873 d. 20 Mar 1914
Hattie E Harvey
b. 27 Sep 1875 d. 7 Feb 1906
12
Mabel Louise Wilson
[1.1.1.1.1.4.5.5.7.10.5.1]
b. 14 Aug 1896 d. 20 Jun 1899
12
Helen Elizabeth Wilson
[1.1.1.1.1.4.5.5.7.10.5.2]
b. 14 Apr 1899 d. 15 Apr 1959 [
=>
]
12
Dora Wilson
[1.1.1.1.1.4.5.5.7.10.5.3]
b. 14 Oct 1901 d. 17 Dec 1989 [
=>
]
11
Everett Wilson
[1.1.1.1.1.4.5.5.7.10.6]
b. 20 Jul 1878 d. 7 Jan 1884
11
Lena L Wilson
[1.1.1.1.1.4.5.5.7.10.7]
b. 11 Oct 1883 d. 21 Dec 1883
11
Maud E Wilson
[1.1.1.1.1.4.5.5.7.10.8]
b. 1886 d. 24 Jan 1907
Frank Barrie Baldwin
b. 30 Dec 1882 d. 26 Apr 1956
12
Harold Gilmore Baldwin
[1.1.1.1.1.4.5.5.7.10.8.1]
b. 26 Nov 1906 d. 15 Feb 1997
9
Fannie Taft
[1.1.1.1.1.4.5.5.8]
b. 14 Jan 1801 d. 3 Sep 1867
9
Emily Taft
[1.1.1.1.1.4.5.5.9]
b. 8 Mar 1803
8
Ezra Taft
[1.1.1.1.1.4.5.6]
b. 22 Dec 1752 d. Aft 1803
8
Ruth Taft
[1.1.1.1.1.4.5.7]
b. 13 May 1763
7
Elizabeth Taft
[1.1.1.1.1.4.6]
b. 30 Oct 1724
Jonathan Penniman
b. 30 Jul 1719 d. 18 Jul 1747
8
Jonathan Peniman
[1.1.1.1.1.4.6.1]
b. 21 Mar 1744 d. 2 Sep 1761
8
Mary Peniman
[1.1.1.1.1.4.6.2]
b. 27 Oct 1746 d. 5 Jul 1749
8
Ann Peniman
[1.1.1.1.1.4.6.3]
b. 26 Aug 1749
8
Adna Penniman
[1.1.1.1.1.4.6.4]
b. 5 Oct 1752 d. 4 Nov 1820
8
Bethiah Peniman
[1.1.1.1.1.4.6.5]
b. 12 Nov 1758
8
Nathan Peniman
[1.1.1.1.1.4.6.6]
b. 26 Nov 1766 d. 11 Jun 1831
7
Aaron Taft
[1.1.1.1.1.4.7]
b. 12 Apr 1727 d. 5 Nov 1805
Marcy Arnold
b. 24 Jan 1733 d. 22 Jan 1806
8
Rhoda Taft
[1.1.1.1.1.4.7.1]
b. 4 Feb 1753 d. 4 Apr 1837
8
Arnold Taft
[1.1.1.1.1.4.7.2]
b. 4 May 1756
8
Thaddeus Taft
[1.1.1.1.1.4.7.3]
b. 13 Dec 1757 d. 5 Sep 1831
8
Patiance Taft
[1.1.1.1.1.4.7.4]
b. 1 Sep 1761 d. 26 Nov 1816
8
Zadock Taft
[1.1.1.1.1.4.7.5]
b. 15 Aug 1763 d. 15 Nov 1843
8
Willis Taft
[1.1.1.1.1.4.7.6]
b. 13 Aug 1765 d. 6 Dec 1841
7
Margaret Taft
[1.1.1.1.1.4.8]
b. 9 Feb 1729
5
Matthew Taft
[1.1.1.1.2]
b. 1642
4
Margaret Taft
[1.1.1.2]
b. 18 Mar 1617 d. 25 Aug 1684
4
Elizabeth Taft
[1.1.1.3]
b. 5 May 1620 d. 9 May 1627
4
Nicholas Taft
[1.1.1.4]
c. 21 Nov 1623 d. Aug 1624
4
Thomas Taft
[1.1.1.5]
b. 12 Oct 1625 d. 1 Dec 1625