Home Page
|
What's New
|
Photos
|
Histories
|
Headstones
|
Reports
|
Surnames
Search
First Name:
Last Name:
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Suomalainen
Svenska
Catherine Finch
1574 - 1635 (61 years)
Submit Photo / Document
Individual
Descendants
Relationship
Timeline
Submit Photo / Doc
Worksheet
Family
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Catherine Finch
[1]
b. 1574 d. 7 Feb 1635
William Byrchard
b. 1569 d. 1634
2
Thomas Birchard
[1.1]
c. 12 Oct 1595 d. 9 May 1684
Mary Robinson
b. 18 Mar 1596 d. 24 Mar 1655
3
Elizabeth Birchard
[1.1.1]
c. 1 Nov 1621 d. 28 Feb 1699
Thomas Bliss
c. 23 Jan 1618 d. 15 Apr 1688
4
Elisabeth Bliss
[1.1.1.1]
b. 20 Nov 1645 d. 10 Jul 1689
4
Sarah Bliss
[1.1.1.2]
b. 26 Aug 1647 d. 29 Aug 1730
4
Mary Bliss
[1.1.1.3]
b. 7 Feb 1649 d. 3 Nov 1688
4
Thomas Bliss
[1.1.1.4]
b. 3 Mar 1652 d. 29 Jan 1682
4
Deliverance Bliss
[1.1.1.5]
b. 10 Aug 1655 d. 30 Dec 1731
4
Samuel Bliss
[1.1.1.6]
b. 9 Dec 1657 d. 30 Dec 1729
4
Anne Bliss
[1.1.1.7]
b. 15 Sep 1660 d. 19 Feb 1714
4
Rebecca Bliss
[1.1.1.8]
b. 18 Mar 1663 d. 22 Aug 1737
3
Mary Birchard
[1.1.2]
c. 2 Apr 1623 d. 30 Jun 1694
3
Sarah Birchard
[1.1.3]
b. 22 Aug 1624 d. 1659
3
Susanna Birchard
[1.1.4]
b. 22 Jun 1626 d. 9 Jun 1682
3
John Birchard
[1.1.5]
c. 31 Jan 1628 d. 1702
Christyan Andrews
b. 1630 d. 1 Dec 1680
4
Thomas Birchard
[1.1.5.1]
b. Oct 1654 d. 1658
4
Katherine Birchard
[1.1.5.2]
b. Nov 1656 d. 1656
4
John Birchard
[1.1.5.3]
b. Jan 1657 d. 1658
4
John Birchard, Jr
[1.1.5.4]
b. Dec 1659 d. 1662
4
Sarah Birchard
[1.1.5.5]
b. May 1661 d. 1664
4
John Birchard
[1.1.5.6]
b. 3 Feb 1662 d. Mar 1662
4
Samuel Birchard
[1.1.5.7]
b. 16 Jul 1665 d. Bef 3 Jan 1713
4
James Birchard
[1.1.5.8]
b. 16 Jul 1665 d. 1745
Elizabeth Beckwith
b. 4 Feb 1678 d. 13 Dec 1767
5
Elizabeth Birchard
[1.1.5.8.1]
b. 2 Sep 1697 d. 6 Jan 1768
Ephraim Tingley
b. 26 Mar 1700 d. Sep 1776
6
Ester Tingley
[1.1.5.8.1.1]
b. Abt 1730 d. 1767
William Jenckes
b. 1724 d. 5 Nov 1815
7
Isabel Jenckes
[1.1.5.8.1.1.1]
b. Abt 1750
+
Joseph Hale
b. 1746
7
William Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2]
b. 1750
Phebe Jenckes
b. 1729 d. Aft 21 Mar 1776
8
Ruth Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.1]
b. 29 Feb 1768 d. 1850
Charles Chase
b. 25 Oct 1762 d. 1850
9
Alanson Chase
[1.1.5.8.1.1.2.1.1]
b. 22 Oct 1795 d. 13 Feb 1875
Maria Harris
b. Abt 1798
10
Albert R Chase
[1.1.5.8.1.1.2.1.1.1]
b. 16 Jul 1824 d. 4 Apr 1825
10
Charles Harris Chase
[1.1.5.8.1.1.2.1.1.2]
b. 19 Feb 1826 d. 9 Jan 1904
Caroline M Ball
b. Abt 1827
11
Louisa M Chase
[1.1.5.8.1.1.2.1.1.2.1]
b. 1853
Abial Fisher
b. 1844
12
Clarrisa Andrews Fisher
[1.1.5.8.1.1.2.1.1.2.1.1]
b. 13 Jun 1873
11
Adeliza Clarrisa Chase
[1.1.5.8.1.1.2.1.1.2.2]
b. 22 Jun 1855 d. Aft 1940
11
Carrie Ruth Chace
[1.1.5.8.1.1.2.1.1.2.3]
b. 4 Jun 1858
11
Emma A Chase
[1.1.5.8.1.1.2.1.1.2.4]
b. 3 Jul 1860
Felton
b. Abt 1860
12
Newell Felton
[1.1.5.8.1.1.2.1.1.2.4.1]
b. 1889
11
Albert Alanson Chase
[1.1.5.8.1.1.2.1.1.2.5]
b. 27 Feb 1863
+
Alice Laura Wilkins
b. 16 Apr 1862
10
Emery Chase
[1.1.5.8.1.1.2.1.1.3]
b. 12 Sep 1829
10
Maria Ann Chase
[1.1.5.8.1.1.2.1.1.4]
b. 1 Feb 1833 d. 24 Oct 1907
William Henry Haskell
b. 29 Oct 1824 d. 2 Dec 1878
11
Alice A Haskell
[1.1.5.8.1.1.2.1.1.4.1]
b. Abt 1856
11
Minnie E Haskell
[1.1.5.8.1.1.2.1.1.4.2]
b. Abt 1858
11
Agnes Haskell
[1.1.5.8.1.1.2.1.1.4.3]
b. Abt 1860
11
Harriet Haskell
[1.1.5.8.1.1.2.1.1.4.4]
b. Abt 1862
+
Clarence Bowers
b. Abt 1858
9
Charles Chase
[1.1.5.8.1.1.2.1.2]
b. 21 Jun 1797 d. 19 Jan 1894
9
Diana Chase
[1.1.5.8.1.1.2.1.3]
b. 28 Aug 1799 d. 24 Aug 1873
9
William J Chase
[1.1.5.8.1.1.2.1.4]
b. Abt Sep 1805 d. 23 May 1806
9
George Ide Chase
[1.1.5.8.1.1.2.1.5]
b. 19 Feb 1808 d. 29 Apr 1885
9
Amy Ann Chase
[1.1.5.8.1.1.2.1.6]
b. 7 Nov 1810
8
Job Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2]
b. 21 Mar 1770 d. 11 Aug 1835
Sarah Aldrich
b. 5 Sep 1778 d. 1 Nov 1836
9
Rosina Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.1]
b. 3 Jun 1795 d. 20 Sep 1865
Joseph P Arnold
b. 18 Feb 1793 d. 21 Apr 1852
10
Lewis B Arnold
[1.1.5.8.1.1.2.2.1.1]
b. 13 Oct 1816
Marietta Kelly
b. Abt 1820
11
Abby Arnold
[1.1.5.8.1.1.2.2.1.1.1]
b. 16 May 1837 d. Bef 1947
11
Anna Arnold
[1.1.5.8.1.1.2.2.1.1.2]
b. 16 May 1837 d. Bef 1947
Mary Dennis
b. Abt 1820
11
Marietta K Arnold
[1.1.5.8.1.1.2.2.1.1.3]
b. Nov 1849
11
Thomas D Arnold
[1.1.5.8.1.1.2.2.1.1.4]
b. Jun 1854
10
Ahiman Arnold
[1.1.5.8.1.1.2.2.1.2]
b. 19 Oct 1818 d. 17 Apr 1881
Prudence J Robinson
b. Abt 1822
11
Charles Edgar Arnold
[1.1.5.8.1.1.2.2.1.2.1]
b. 11 Feb 1842 d. 10 Jul 1890
Hariett Louise Wheat
b. 3 Oct 1845 d. 9 Sep 1928
12
Carrie Frances Arnold
[1.1.5.8.1.1.2.2.1.2.1.1]
b. 29 Aug 1877 d. 2 Mar 1966
12
Anna Louise Arnold
[1.1.5.8.1.1.2.2.1.2.1.2]
b. 26 Aug 1881 d. 21 Dec 1963
11
Harriet E Arnold
[1.1.5.8.1.1.2.2.1.2.2]
b. 6 Apr 1844
11
Rosina Arnold
[1.1.5.8.1.1.2.2.1.2.3]
b. 24 Feb 1846
Lucy B Aldrich
b. 2 Jan 1827 d. 25 Jan 1869
11
Joseph A Arnold
[1.1.5.8.1.1.2.2.1.2.4]
b. 2 Apr 1852 d. 1899
11
Walter James Arnold
[1.1.5.8.1.1.2.2.1.2.5]
b. 20 Apr 1853 d. 22 Mar 1929
Anna Patterson Wheat
b. 16 Apr 1854 d. 6 Aug 1933
12
Lucy Frances Arnold
[1.1.5.8.1.1.2.2.1.2.5.1]
b. 1881
12
Walter Aldrich Arnold
[1.1.5.8.1.1.2.2.1.2.5.2]
b. 24 Jan 1887 d. 25 Feb 1972
12
Morris Josiah Arnold
[1.1.5.8.1.1.2.2.1.2.5.3]
b. 24 Jan 1887 d. 4 Jan 1968 [
=>
]
12
Charles Edgar Arnold
[1.1.5.8.1.1.2.2.1.2.5.4]
b. 25 Feb 1893 d. 12 Dec 1937
11
Ida Jane Arnold
[1.1.5.8.1.1.2.2.1.2.6]
b. 3 Apr 1855 d. 25 Feb 1934
+
William Cooper
b. 24 Nov 1861 d. 23 Jan 1914
11
Mary Edith Arnold
[1.1.5.8.1.1.2.2.1.2.7]
b. 1 Sep 1857 d. 23 May 1910
Frank W Daily
b. 16 Mar 1850 d. 12 Oct 1909
12
Margaret Daily
[1.1.5.8.1.1.2.2.1.2.7.1]
b. 24 Sep 1884 d. 2 Dec 1976
11
Carrie Elizabeth Arnold
[1.1.5.8.1.1.2.2.1.2.8]
b. 31 Jul 1860 d. 20 May 1943
+
Louis August Manlove
b. Abt 1856
+
Sydney Rosworn
b. Abt 1856
11
Luela Minerva Arnold
[1.1.5.8.1.1.2.2.1.2.9]
b. 24 Mar 1861 d. 11 Apr 1930
William Albert Smiley
b. Abt 1857 d. 1944
12
Stanton L Smiley
[1.1.5.8.1.1.2.2.1.2.9.1]
b. 19 Jan 1895 d. 2 May 1973
10
Louisa M Arnold
[1.1.5.8.1.1.2.2.1.3]
b. 10 Nov 1820
Augusta Adlington
b. Abt 1816
11
Joseph A Adlington
[1.1.5.8.1.1.2.2.1.3.1]
b. 12 Jan 1842 d. Bef 1952
11
Maria E Adlington
[1.1.5.8.1.1.2.2.1.3.2]
b. 20 Sep 1843 d. Bef 1953
11
Harriet Adlington
[1.1.5.8.1.1.2.2.1.3.3]
b. Sep 1848 d. Bef 1958
10
Sarah A Arnold
[1.1.5.8.1.1.2.2.1.4]
b. 23 Mar 1823 d. 3 Mar 1914
George C Wilder
b. Abt 1819
11
Rosina J Wilder
[1.1.5.8.1.1.2.2.1.4.1]
b. 11 Jun 1845 d. Bef 1850
11
Ella F Wilder
[1.1.5.8.1.1.2.2.1.4.2]
b. 28 Jul 1846 d. Bef 1956
10
Lucien J Arnold
[1.1.5.8.1.1.2.2.1.5]
b. 3 Mar 1826 d. 20 Aug 1887
10
Elizabeth Arnold
[1.1.5.8.1.1.2.2.1.6]
b. 7 Aug 1828
Loring Boyden
b. Aug 1817 d. Bef 1927
11
Charles L Boyden
[1.1.5.8.1.1.2.2.1.6.1]
b. 11 Feb 1847
11
Medora E Boyden
[1.1.5.8.1.1.2.2.1.6.2]
b. 28 Dec 1849 d. Bef 1959
11
Clara Stanton Boyden
[1.1.5.8.1.1.2.2.1.6.3]
b. May 1856 d. Bef 1966
10
Mary E Arnold
[1.1.5.8.1.1.2.2.1.7]
b. 16 May 1831
10
Alice A Arnold
[1.1.5.8.1.1.2.2.1.8]
b. 11 Aug 1834
+
Benjamin W Johnson
b. 29 Jan 1819
10
Helen M Arnold
[1.1.5.8.1.1.2.2.1.9]
b. 23 Jun 1837
10
Emily Boyden Arnold
[1.1.5.8.1.1.2.2.1.10]
b. 12 Mar 1840 d. 27 Aug 1888
Orlando Samuel Stetson
b. 25 Apr 1832 d. 31 May 1921
11
John Stetson
[1.1.5.8.1.1.2.2.1.10.1]
b. Abt 1861 d. Abt 1871
11
Florence Stetson
[1.1.5.8.1.1.2.2.1.10.2]
b. Abt 1863 d. Abt 1873
11
Orlando Samuel Stetson
[1.1.5.8.1.1.2.2.1.10.3]
b. 6 Aug 1877 d. Bef 1967
9
Nelson J Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.2]
b. 22 Jul 1797 d. 23 Jan 1855
Deborah Wheelock Morse
b. 27 Feb 1782 d. 27 Feb 1872
10
Arnold A Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.2.1]
b. 19 Oct 1822 d. 1 Dec 1824
10
Olive A Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.2.2]
b. 9 Jan 1824
Nathaniel Elliot
b. 25 Mar 1821
11
Edgar C Elliot
[1.1.5.8.1.1.2.2.2.2.1]
b. 9 Nov 1844 d. 16 Jun 1857
11
Hattie Oliva Elliott
[1.1.5.8.1.1.2.2.2.2.2]
b. 26 Jan 1853 d. 20 Jun 1876
George Willard Spaulding
b. 29 Jun 1843
12
Edgar Le Roy Spalding
[1.1.5.8.1.1.2.2.2.2.2.1]
b. 26 Sep 1874 [
=>
]
11
Ida A Elliot
[1.1.5.8.1.1.2.2.2.2.3]
b. 11 Mar 1847 d. 28 Aug 1847
11
Charles U Elliott
[1.1.5.8.1.1.2.2.2.2.4]
b. 11 Mar 1848
11
Charles N Elliot
[1.1.5.8.1.1.2.2.2.2.5]
b. 12 Mar 1849
+
Mattie Tyler
b. Abt 1851
11
Anna Augusta Elliott
[1.1.5.8.1.1.2.2.2.2.6]
b. 31 Jan 1851 d. 24 Feb 1875
Walter Edward Parker
b. 28 Sep 1847
12
Herbert Sumner Parker
[1.1.5.8.1.1.2.2.2.2.6.1]
b. 18 Oct 1874
11
Horace Jenckes Elliott
[1.1.5.8.1.1.2.2.2.2.7]
b. 25 Jan 1860
Bertha Simmons Foss
b. Abt 1862
12
Samuel Foss Elliott
[1.1.5.8.1.1.2.2.2.2.7.1]
b. Abt 1885
12
Charles Hendrick Elliott
[1.1.5.8.1.1.2.2.2.2.7.2]
b. 10 Feb 1886 d. 15 Aug 1886
10
Lydia Elizabeth Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.2.3]
b. 5 May 1828
William M Whitaker
b. 2 Dec 1824
11
Edward Stanley Whitaker
[1.1.5.8.1.1.2.2.2.3.1]
b. 19 Mar 1848 d. 1922
Mary Anna Walsh
b. 1849 d. 1 Jun 1880
12
Daughter Whitaker
[1.1.5.8.1.1.2.2.2.3.1.1]
b. 20 Apr 1874
12
Walter S Whitaker
[1.1.5.8.1.1.2.2.2.3.1.2]
b. Dec 1875
12
Daughter Whitaker
[1.1.5.8.1.1.2.2.2.3.1.3]
b. 13 Dec 1877 d. 13 Dec 1877
+
Mary Elizabeth Ware
b. 17 Feb 1848 d. 1 Oct 1926
11
Sidney Augustus Whitaker
[1.1.5.8.1.1.2.2.2.3.2]
b. 9 Feb 1850
11
Marcial Stewart Whitaker
[1.1.5.8.1.1.2.2.2.3.3]
b. 23 Nov 1854 d. 15 Jul 1914
10
Elias Morse Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.2.4]
b. 24 Dec 1826 d. 29 Oct 1892
Sarah Sweetland Arnold
b. 8 Sep 1828 d. Bef 1943
11
Nellie Beebe Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.2.4.1]
b. 19 Oct 1855
11
Ida Alice Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.2.4.2]
b. 10 Nov 1857
10
Andrew Nelson Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.2.5]
b. 22 Sep 1831 d. 13 Jan 1884
Lydia Hart Coggeshall
b. 14 Jul 1842 d. Bef 1953
11
Henry Nelson Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.2.5.1]
b. 10 Apr 1860 d. 14 Aug 1871
11
Edgar Burnside Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.2.5.2]
b. 24 Sep 1862 d. 29 Oct 1865
11
Lillian May Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.2.5.3]
b. 22 Dec 1864
+
Charles Harris Gorton
b. 7 Aug 1853
11
Edith Louise Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.2.5.4]
b. 27 Aug 1870 d. 25 Aug 1871
11
Hattie Olive Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.2.5.5]
b. 10 Jul 1873
+
Fred Lester Horton
b. 25 Jul 1869
11
William Herbert Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.2.5.6]
b. 23 Jun 1875
+
Mary Jane Heaslip
b. 25 Dec 1875
11
Daughter Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.2.5.7]
b. 13 Mar 1879
11
Rachel Louise Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.2.5.8]
b. 20 Mar 1879
10
Sarah E Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.2.6]
b. 11 Nov 1835 d. 22 Aug 1836
10
Ellen A Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.2.7]
b. 3 Jan 1838 d. 5 Dec 1838
10
Horace Adelbert Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.2.8]
b. 23 Sep 1841 d. 10 Oct 1889
Almira Arnold Scott
b. 11 Jun 1841 d. 8 Feb 1919
11
Clara Nettie Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.2.8.1]
b. 11 Dec 1860 d. 17 Aug 1862
11
Nelson Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.2.8.2]
b. 8 Oct 1862 d. Oct 1935
Helen Rayner Aldrich
b. 15 Sep 1864
12
Leland Aldrich Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.2.8.2.1]
b. 27 Apr 1886 d. 4 Oct 1919
12
Horace A Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.2.8.2.2]
b. 6 Jan 1890 d. 7 Jan 1890
10
Bartoa W Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.2.9]
b. 24 Oct 1845 d. 24 Jun 1846
9
George Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.3]
b. 15 Jun 1799 d. 12 Dec 1869
Abigail Farnum
b. 15 Jan 1797 d. 30 Jan 1822
10
William H Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.3.1]
b. 22 Dec 1823 d. 12 Nov 1877
Amey Ann Kent
b. Abt 1825
11
Walter I Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.3.1.1]
b. 2 Sep 1855
11
Frederic W Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.3.1.2]
b. 29 Oct 1856
11
Emma Frances Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.3.1.3]
b. 4 May 1858 d. 1 Apr 1941
Waldo Stephen Cook
b. 17 Sep 1857 d. 30 Dec 1927
12
Son Cook
[1.1.5.8.1.1.2.2.3.1.3.1]
b. 5 Jul 1879 d. 6 Jul 1879
12
Amy Jenckes Cook
[1.1.5.8.1.1.2.2.3.1.3.2]
b. 9 Jul 1880 d. 5 Jul 1979
12
Lucius Alonzo Cook
[1.1.5.8.1.1.2.2.3.1.3.3]
b. 6 Apr 1882 d. 28 Feb 1940
12
Maude Elaine Cook
[1.1.5.8.1.1.2.2.3.1.3.4]
b. 1 Apr 1885 d. 12 Feb 1985
12
Herbert Leonard Cook
[1.1.5.8.1.1.2.2.3.1.3.5]
b. 24 Jul 1889 d. 7 Aug 1919
12
Austin Harold Cook
[1.1.5.8.1.1.2.2.3.1.3.6]
b. 5 Nov 1891 d. 24 May 1972 [
=>
]
12
Sarah Elizabeth Cook
[1.1.5.8.1.1.2.2.3.1.3.7]
b. 23 Oct 1893 d. 21 Dec 1932
12
William Stanton Cook
[1.1.5.8.1.1.2.2.3.1.3.8]
b. 10 Apr 1895 d. 4 Jun 1945
12
Fred Russell Cook
[1.1.5.8.1.1.2.2.3.1.3.9]
b. 3 Jan 1899 d. 15 Mar 1932
11
Sarah Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.3.1.4]
b. 17 Aug 1859 d. 10 Apr 1925
+
George R Smith
b. Abt 1861
10
Edwin Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.3.2]
b. 9 Jan 1826 d. 12 Jun 1895
Mary Adaline Johnson
b. 21 Oct 1829 d. 11 Nov 1851
11
Joseph Edwin Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.3.2.1]
b. 18 Aug 1851 d. 6 Jan 1910
Frederica Clark
b. 12 Dec 1850 d. 25 Sep 1940
12
Robert Johnson Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.3.2.1.1]
b. 16 Dec 1873 d. 11 Feb 1929
12
Mary Church Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.3.2.1.2]
b. 13 Feb 1876 [
=>
]
12
Frederick L Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.3.2.1.3]
b. 4 Apr 1877
12
Josephine Densay Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.3.2.1.4]
b. Abt 1879 d. 24 Nov 1883
Harriet Eliza Morse
b. 5 Jan 1824 d. 31 Jan 1871
11
Latimer Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.3.2.2]
b. 8 Aug 1860
11
Harriet Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.3.2.3]
b. 1862 d. 21 Aug 1909
11
Adaline Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.3.2.4]
b. 1864
11
Edwin Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.3.2.5]
b. 1866
Martha Thornton
b. 12 Jun 1851 d. 4 Oct 1933
11
Edwin Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.3.2.6]
b. Abt 1874
10
George W Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.3.3]
b. 17 Aug 1829 d. 27 Jan 1913
Martha Ann Hunt
b. Abt 1831
11
Frank Herbert Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.3.3.1]
b. 26 Jan 1860
+
Smith
b. Abt 1862
+
Mabel Rathburn
b. Abt 1862
11
Waldo Warner Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.3.3.2]
b. 4 Oct 1861
11
Clara Hunt Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.3.3.3]
b. 1 Jan 1865
11
Earl Stanton Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.3.3.4]
b. 9 May 1872
+
Grace L Rankin
b. Abt 1874
10
Leander Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.3.4]
b. 30 Jan 1832 d. 11 Apr 1861
+
Clarissa Ann Jenette Whipple
b. 8 May 1836
10
Ferdinand Lawton Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.3.5]
b. 19 Jan 1834
Amelia Melissa Whipple
b. 3 Jun 1834
11
Daughter Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.3.5.1]
b. 21 Oct 1858
11
Charles F Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.3.5.2]
b. Abt 1860 d. 15 Jan 1937
11
Oscar I Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.3.5.3]
b. Abt 1862
+
Ida E Lynch Morey
b. Abt 1864
11
Jessie F Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.3.5.4]
b. Abt 1870 d. 25 Mar 1874
11
Mabel Viola Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.3.5.5]
b. 21 May 1878 d. 1918
11
Medora A Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.3.5.6]
b. Abt 1880
+
Jesse Albert Carpenter
b. Abt 1878
11
George Washington Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.3.5.7]
b. Abt 1882
+
Elizabeth Kathleen Murray
b. Abt 1884
10
Sarah E Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.3.6]
b. 20 Feb 1837 d. 10 Apr 1860
9
Wheaton Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.4]
b. 26 Sep 1801 d. 4 Sep 1803
9
Barton J Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.5]
b. 8 Jan 1804 d. 16 Jun 1834
Amelia Cook
b. 13 Feb 1808 d. 21 May 1838
10
Harriet Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.5.1]
b. 26 Aug 1832 d. 1 Jun 1834
10
Frederick Barton Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.5.2]
b. 15 Jan 1834 d. 11 Feb 1835
9
Charles Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.6]
b. 28 Jul 1806 d. 30 Aug 1861
Louisa Cook
b. 15 Nov 1809 d. 6 Oct 1894
10
Henry C Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.6.1]
b. Abt 1831
+
Helen Frances Mowry
b. Abt 1833 d. 29 Aug 1894
10
Allen Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.6.2]
b. Abt 1833 d. 10 Jul 1907
Sarah Louisa Thayer
b. 17 Mar 1838
11
Isabel F Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.6.2.1]
b. 7 May 1861 d. 21 May 1863
11
Charles Allen Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.6.2.2]
b. 27 May 1869
10
Fred B Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.6.3]
b. Abt 1833
10
Estelle Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.6.4]
b. Abt 1837
+
Waldo Slocomb
b. Abt 1835
10
Lucy A Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.6.5]
b. Abt 1839
9
Albert Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.7]
b. 13 Feb 1809
Elizabeth Maria Pratt
b. 6 Jul 1815
10
Levilla Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.7.1]
b. 1840
10
Mary Deloss Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.7.2]
b. 22 May 1842 d. 20 Aug 1843
10
Albert Oscar Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.7.3]
b. 18 May 1846 d. 30 Mar 1866
10
Henry Pratt Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.7.4]
b. 27 Sep 1849 d. 13 May 1855
10
Charles Fremont Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.7.5]
b. 19 Feb 1854 d. 11 Mar 1896
10
Emma Frances Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.7.6]
b. 3 Nov 1858 d. 15 Aug 1860
9
Mary Ann Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.8]
b. 2 Jul 1811 d. 24 Nov 1836
+
Christopher Robinson
b. 15 May 1806
9
Julia E Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.9]
b. 31 Jul 1813 d. 31 Dec 1872
Aaron Rathbone
b. 24 Apr 1804 d. 24 Mar 1854
10
Oscar J Rathbone
[1.1.5.8.1.1.2.2.9.1]
b. 12 Mar 1832
+
Israel White
b. Abt 1809
9
William Augustus Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.10]
b. 12 Jun 1815 d. 19 Aug 1899
Lucilla Laura Tourtellot Young
b. 5 Sep 1816 d. 8 Feb 1843
10
Earl Francis Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.10.1]
b. 20 Jul 1838 d. 28 Apr 1853
10
Leland Delos Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.10.2]
b. 27 Nov 1839 d. 25 Aug 1872
+
Arabella Holder
b. Abt 1841
Adelia Crooks
b. 10 Sep 1832 d. 9 Apr 1909
10
Mary Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.10.3]
b. Abt 1856
10
Barton C Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.10.4]
b. 27 Aug 1857 d. 13 Mar 1897
10
Marianna Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.10.5]
b. 23 Nov 1859 d. 4 Mar 1951
George P Cooke
b. Abt 1857 d. 1914
11
Allan Jencks Cooke
[1.1.5.8.1.1.2.2.10.5.1]
b. 6 Dec 1884 d. 1942
11
Guenn Cooke
[1.1.5.8.1.1.2.2.10.5.2]
b. 4 Jul 1887
11
Mildred A Cooke
[1.1.5.8.1.1.2.2.10.5.3]
b. 10 Aug 1890
11
Mary J Cooke
[1.1.5.8.1.1.2.2.10.5.4]
b. 14 Nov 1894
10
Grace A Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.10.6]
b. 23 Dec 1866
+
George H Dame
b. Abt 1864
10
Florence E Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.10.7]
b. 14 Mar 1863
John Bradford Spencer
b. Abt 1861
11
Bradford Jenckes Spencer
[1.1.5.8.1.1.2.2.10.7.1]
b. 19 Nov 1890
+
Marion L Moule
b. 22 Feb 1895
10
William Francis Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.10.8]
b. 1 Jul 1875 d. 1 Oct 1875
9
Harriet Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.11]
b. 5 Aug 1819 d. 29 Sep 1820
9
Horace Aldrich Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.12]
b. 8 Apr 1822 d. 24 Apr 1840
9
Edwin Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.13]
b. 9 Jan 1826 d. 12 Jun 1895
Mary Adaline Johnson
b. 21 Oct 1829 d. 11 Nov 1851
10
Joseph Edwin Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.13.1]
b. 18 Aug 1851 d. 6 Jan 1910
Frederica Clark
b. 12 Dec 1850 d. 25 Sep 1940
11
Robert Johnson Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.13.1.1]
b. 16 Dec 1873 d. 11 Feb 1929
11
Mary Church Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.13.1.2]
b. 13 Feb 1876
Isaac Butts Merriman
b. 8 Oct 1874
12
Marie Merriman
[1.1.5.8.1.1.2.2.13.1.2.1]
b. 1902
12
Isaac B Merriman
[1.1.5.8.1.1.2.2.13.1.2.2]
b. 1903
11
Frederick L Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.13.1.3]
b. 4 Apr 1877
11
Josephine Densay Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.13.1.4]
b. Abt 1879 d. 24 Nov 1883
Harriet Eliza Morse
b. 5 Jan 1824 d. 31 Jan 1871
10
Latimer Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.13.2]
b. 8 Aug 1860
10
Harriet Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.13.3]
b. 1862 d. 21 Aug 1909
10
Adaline Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.13.4]
b. 1864
10
Edwin Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.13.5]
b. 1866
Martha Thornton
b. 12 Jun 1851 d. 4 Oct 1933
10
Edwin Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.2.13.6]
b. Abt 1874
8
Mary Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.3]
b. 24 Nov 1772 d. 4 Jan 1818
8
Luke Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.4]
b. 1774 d. 13 Oct 1848
Robey Arnold
b. 2 Oct 1778 d. 22 Aug 1875
9
Lydia Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.4.1]
b. 1800 d. 21 Jul 1876
9
Luke Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.4.2]
b. 1803 d. 15 Mar 1843
Betsey Ballou
b. 21 Oct 1799 d. 25 Sep 1870
10
Arnold Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.4.2.1]
b. 17 Aug 1832 d. 29 Jul 1846
10
Marcien Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.4.2.2]
b. 23 Jun 1834 d. 15 Mar 1912
Amelia Marcon Bates
b. 22 May 1838 d. 12 Apr 1916
11
Anna Amelia Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.4.2.2.1]
b. 30 Oct 1860
Louis Harding
b. Abt 1859
12
Louis Harding
[1.1.5.8.1.1.2.4.2.2.1.1]
b. Abt 1880
12
Lawrence Harding
[1.1.5.8.1.1.2.4.2.2.1.2]
b. Abt 1882
12
Nanette Harding
[1.1.5.8.1.1.2.4.2.2.1.3]
b. Abt 1884
12
Lucy Harding
[1.1.5.8.1.1.2.4.2.2.1.4]
b. Abt 1886
12
Amelia Harding
[1.1.5.8.1.1.2.4.2.2.1.5]
b. Abt 1888
11
Lawrence Bates Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.4.2.2.2]
b. 23 Mar 1867 d. 9 Mar 1922
Alice Child
b. 2 Jan 1861 d. 23 Dec 1945
12
Marcian Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.4.2.2.2.1]
b. 5 Apr 1900
10
Asbert Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.4.2.3]
b. 5 Jul 1836
10
Celia Maria Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.4.2.4]
b. 8 Jun 1838
Joseph P Pillsbury
b. Abt 1836 d. 28 Oct 1877
11
Sherman J Pillsbury
[1.1.5.8.1.1.2.4.2.4.1]
b. 23 Oct 1863
11
Bertha Pillsbury
[1.1.5.8.1.1.2.4.2.4.2]
b. 16 Jul 1865
10
Ella Amelia Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.4.2.5]
b. 22 Sep 1841
8
Diana Jenckes
[1.1.5.8.1.1.2.5]
b. 1 Jan 1776 d. 11 Aug 1847
6
Phoebe Tingley
[1.1.5.8.1.2]
b. 12 Dec 1732 d. 16 Feb 1807
6
Phillis Tingley
[1.1.5.8.1.3]
b. 30 Dec 1734
6
Elizabeth Tingley
[1.1.5.8.1.4]
b. 20 Nov 1736
6
Rebekah Tingley
[1.1.5.8.1.5]
b. 4 Feb 1739
6
Anna Tingley
[1.1.5.8.1.6]
b. 13 Nov 1741
6
Sarah Tingely
[1.1.5.8.1.7]
b. 9 Sep 1744
6
Ephraim Tingley
[1.1.5.8.1.8]
b. 12 Jul 1746
5
James Birchard
[1.1.5.8.2]
b. 3 May 1699 bur. 1782
5
Sarah Birchard
[1.1.5.8.3]
b. 10 Jul 1701 d. 15 Aug 1701
5
Matthew Birchard
[1.1.5.8.4]
b. 5 Dec 1702 d. 18 Jan 1726
+
Ruth Hartshorn
b. 12 May 1706 d. Aft 1750
5
Phebe Birchard
[1.1.5.8.5]
b. Oct 1705 d. 13 Mar 1791
5
Sarah Birchard
[1.1.5.8.6]
b. 9 Oct 1711 d. 13 Mar 1791
5
Rebecca Birchard
[1.1.5.8.7]
b. 1717 d. 1719
5
Daniel Birchard
[1.1.5.8.8]
b. 9 May 1718 d. 1780
4
Abigail Birchard
[1.1.5.9]
b. 12 Nov 1667 d. 23 Aug 1741
4
Thomas Birchard
[1.1.5.10]
b. Jan 1669 d. 21 Mar 1741
4
John Birchard
[1.1.5.11]
b. Feb 1671 d. 30 Jun 1735
4
Joseph Birchard
[1.1.5.12]
b. Feb 1673 d. 9 Mar 1755
4
Benjamin Birchard
[1.1.5.13]
b. Dec 1675 d. Dec 1675
4
Mary Birchard
[1.1.5.14]
b. Jun 1677 d. Aft 11 Apr 1758
Jonathan Hartshorn
b. 14 May 1677 d. 1 Nov 1751
5
Mary Hartshorn
[1.1.5.14.1]
b. Jun 1701 d. 1752
5
Ruth Hartshorn
[1.1.5.14.2]
b. 31 Dec 1703 d. 1759
5
Abigail Hartshorn
[1.1.5.14.3]
b. 1 Feb 1705 d. 1 May 1789
5
Ruth Hartshorn
[1.1.5.14.4]
b. 12 May 1706 d. Aft 1750
+
Matthew Birchard
b. 5 Dec 1702 d. 18 Jan 1726
James Dickinson
b. 31 Dec 1705 d. 27 Jun 1756
6
Mary Dickinson
[1.1.5.14.4.1]
b. 20 Feb 1728
6
Submit Dickinson
[1.1.5.14.4.2]
b. 29 Jun 1731 d. 1788
6
Ruth Dickson
[1.1.5.14.4.3]
b. 3 Mar 1734
6
James Dickinson
[1.1.5.14.4.4]
b. 1 Aug 1736 d. Aft 1775
6
Jonathan Dickinson
[1.1.5.14.4.5]
b. 18 Nov 1738 d. 16 Oct 1762
Abigail Whipple
b. 30 Jan 1729 d. 21 Apr 1806
7
Mary Dickinson
[1.1.5.14.4.5.1]
b. 25 Dec 1758 d. 5 Mar 1759
7
Jonathan Dickinson
[1.1.5.14.4.5.2]
b. 30 Sep 1760
7
Mary Dickinson
[1.1.5.14.4.5.3]
b. Mar 1762 d. May 1850
6
Noah Dickinson
[1.1.5.14.4.6]
b. 14 Mar 1741 d. 16 Jan 1828
6
Mathew Dickinson
[1.1.5.14.4.7]
b. 14 Apr 1743 d. 21 Sep 1762
6
Ruth Dickinson
[1.1.5.14.4.8]
b. 29 Jul 1745 d. 22 Nov 1834
6
Love Dickinson
[1.1.5.14.4.9]
b. 2 Jun 1750
5
Hannah Hartshorn
[1.1.5.14.5]
b. 2 Dec 1709 d. 21 Jun 1779
5
Lydia Hartshorn
[1.1.5.14.6]
b. 12 Apr 1711 d. 10 Dec 1726
5
John Hartshorn
[1.1.5.14.7]
b. 19 Nov 1715 d. Aft 1750
5
Jonathan Hartshorn
[1.1.5.14.8]
b. 25 Oct 1717 d. 1796
5
Zerviah Hartshorn
[1.1.5.14.9]
b. 27 Jan 1719 d. 1775
2
William Birchard
[1.2]
b. 28 May 1598 bur. 10 Oct 1625
2
Richard Birchard
[1.3]
b. Jul 1600 d. 1684
2
Mary Birchard
[1.4]
b. Jun 1606 d. 12 Dec 1681
2
Katherine Birchard
[1.5]
b. 15 Apr 1608 d. Aft 4 Mar 1674
Henry Andrews
b. 1608 d. 3 Mar 1652
3
Christyan Andrews
[1.5.1]
b. 1630 d. 1 Dec 1680
John Birchard
c. 31 Jan 1628 d. 1702
4
Thomas Birchard
[1.5.1.1]
b. Oct 1654 d. 1658
4
Katherine Birchard
[1.5.1.2]
b. Nov 1656 d. 1656
4
John Birchard
[1.5.1.3]
b. Jan 1657 d. 1658
4
John Birchard, Jr
[1.5.1.4]
b. Dec 1659 d. 1662
4
Sarah Birchard
[1.5.1.5]
b. May 1661 d. 1664
4
John Birchard
[1.5.1.6]
b. 3 Feb 1662 d. Mar 1662
4
Samuel Birchard
[1.5.1.7]
b. 16 Jul 1665 d. Bef 3 Jan 1713
4
James Birchard
[1.5.1.8]
b. 16 Jul 1665 d. 1745
Elizabeth Beckwith
b. 4 Feb 1678 d. 13 Dec 1767
5
Elizabeth Birchard
[1.5.1.8.1]
b. 2 Sep 1697 d. 6 Jan 1768
Ephraim Tingley
b. 26 Mar 1700 d. Sep 1776
6
Ester Tingley
[1.5.1.8.1.1]
b. Abt 1730 d. 1767
William Jenckes
b. 1724 d. 5 Nov 1815
7
Isabel Jenckes
[1.5.1.8.1.1.1]
b. Abt 1750
+
Joseph Hale
b. 1746
7
William Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2]
b. 1750
Phebe Jenckes
b. 1729 d. Aft 21 Mar 1776
8
Ruth Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.1]
b. 29 Feb 1768 d. 1850
Charles Chase
b. 25 Oct 1762 d. 1850
9
Alanson Chase
[1.5.1.8.1.1.2.1.1]
b. 22 Oct 1795 d. 13 Feb 1875
Maria Harris
b. Abt 1798
10
Albert R Chase
[1.5.1.8.1.1.2.1.1.1]
b. 16 Jul 1824 d. 4 Apr 1825
10
Charles Harris Chase
[1.5.1.8.1.1.2.1.1.2]
b. 19 Feb 1826 d. 9 Jan 1904
Caroline M Ball
b. Abt 1827
11
Louisa M Chase
[1.5.1.8.1.1.2.1.1.2.1]
b. 1853
Abial Fisher
b. 1844
12
Clarrisa Andrews Fisher
[1.5.1.8.1.1.2.1.1.2.1.1]
b. 13 Jun 1873
11
Adeliza Clarrisa Chase
[1.5.1.8.1.1.2.1.1.2.2]
b. 22 Jun 1855 d. Aft 1940
11
Carrie Ruth Chace
[1.5.1.8.1.1.2.1.1.2.3]
b. 4 Jun 1858
11
Emma A Chase
[1.5.1.8.1.1.2.1.1.2.4]
b. 3 Jul 1860
Felton
b. Abt 1860
12
Newell Felton
[1.5.1.8.1.1.2.1.1.2.4.1]
b. 1889
11
Albert Alanson Chase
[1.5.1.8.1.1.2.1.1.2.5]
b. 27 Feb 1863
+
Alice Laura Wilkins
b. 16 Apr 1862
10
Emery Chase
[1.5.1.8.1.1.2.1.1.3]
b. 12 Sep 1829
10
Maria Ann Chase
[1.5.1.8.1.1.2.1.1.4]
b. 1 Feb 1833 d. 24 Oct 1907
William Henry Haskell
b. 29 Oct 1824 d. 2 Dec 1878
11
Alice A Haskell
[1.5.1.8.1.1.2.1.1.4.1]
b. Abt 1856
11
Minnie E Haskell
[1.5.1.8.1.1.2.1.1.4.2]
b. Abt 1858
11
Agnes Haskell
[1.5.1.8.1.1.2.1.1.4.3]
b. Abt 1860
11
Harriet Haskell
[1.5.1.8.1.1.2.1.1.4.4]
b. Abt 1862
+
Clarence Bowers
b. Abt 1858
9
Charles Chase
[1.5.1.8.1.1.2.1.2]
b. 21 Jun 1797 d. 19 Jan 1894
9
Diana Chase
[1.5.1.8.1.1.2.1.3]
b. 28 Aug 1799 d. 24 Aug 1873
9
William J Chase
[1.5.1.8.1.1.2.1.4]
b. Abt Sep 1805 d. 23 May 1806
9
George Ide Chase
[1.5.1.8.1.1.2.1.5]
b. 19 Feb 1808 d. 29 Apr 1885
9
Amy Ann Chase
[1.5.1.8.1.1.2.1.6]
b. 7 Nov 1810
8
Job Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2]
b. 21 Mar 1770 d. 11 Aug 1835
Sarah Aldrich
b. 5 Sep 1778 d. 1 Nov 1836
9
Rosina Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.1]
b. 3 Jun 1795 d. 20 Sep 1865
Joseph P Arnold
b. 18 Feb 1793 d. 21 Apr 1852
10
Lewis B Arnold
[1.5.1.8.1.1.2.2.1.1]
b. 13 Oct 1816
Marietta Kelly
b. Abt 1820
11
Abby Arnold
[1.5.1.8.1.1.2.2.1.1.1]
b. 16 May 1837 d. Bef 1947
11
Anna Arnold
[1.5.1.8.1.1.2.2.1.1.2]
b. 16 May 1837 d. Bef 1947
Mary Dennis
b. Abt 1820
11
Marietta K Arnold
[1.5.1.8.1.1.2.2.1.1.3]
b. Nov 1849
11
Thomas D Arnold
[1.5.1.8.1.1.2.2.1.1.4]
b. Jun 1854
10
Ahiman Arnold
[1.5.1.8.1.1.2.2.1.2]
b. 19 Oct 1818 d. 17 Apr 1881
Prudence J Robinson
b. Abt 1822
11
Charles Edgar Arnold
[1.5.1.8.1.1.2.2.1.2.1]
b. 11 Feb 1842 d. 10 Jul 1890
Hariett Louise Wheat
b. 3 Oct 1845 d. 9 Sep 1928
12
Carrie Frances Arnold
[1.5.1.8.1.1.2.2.1.2.1.1]
b. 29 Aug 1877 d. 2 Mar 1966
12
Anna Louise Arnold
[1.5.1.8.1.1.2.2.1.2.1.2]
b. 26 Aug 1881 d. 21 Dec 1963
11
Harriet E Arnold
[1.5.1.8.1.1.2.2.1.2.2]
b. 6 Apr 1844
11
Rosina Arnold
[1.5.1.8.1.1.2.2.1.2.3]
b. 24 Feb 1846
Lucy B Aldrich
b. 2 Jan 1827 d. 25 Jan 1869
11
Joseph A Arnold
[1.5.1.8.1.1.2.2.1.2.4]
b. 2 Apr 1852 d. 1899
11
Walter James Arnold
[1.5.1.8.1.1.2.2.1.2.5]
b. 20 Apr 1853 d. 22 Mar 1929
Anna Patterson Wheat
b. 16 Apr 1854 d. 6 Aug 1933
12
Lucy Frances Arnold
[1.5.1.8.1.1.2.2.1.2.5.1]
b. 1881
12
Walter Aldrich Arnold
[1.5.1.8.1.1.2.2.1.2.5.2]
b. 24 Jan 1887 d. 25 Feb 1972
12
Morris Josiah Arnold
[1.5.1.8.1.1.2.2.1.2.5.3]
b. 24 Jan 1887 d. 4 Jan 1968 [
=>
]
12
Charles Edgar Arnold
[1.5.1.8.1.1.2.2.1.2.5.4]
b. 25 Feb 1893 d. 12 Dec 1937
11
Ida Jane Arnold
[1.5.1.8.1.1.2.2.1.2.6]
b. 3 Apr 1855 d. 25 Feb 1934
+
William Cooper
b. 24 Nov 1861 d. 23 Jan 1914
11
Mary Edith Arnold
[1.5.1.8.1.1.2.2.1.2.7]
b. 1 Sep 1857 d. 23 May 1910
Frank W Daily
b. 16 Mar 1850 d. 12 Oct 1909
12
Margaret Daily
[1.5.1.8.1.1.2.2.1.2.7.1]
b. 24 Sep 1884 d. 2 Dec 1976
11
Carrie Elizabeth Arnold
[1.5.1.8.1.1.2.2.1.2.8]
b. 31 Jul 1860 d. 20 May 1943
+
Louis August Manlove
b. Abt 1856
+
Sydney Rosworn
b. Abt 1856
11
Luela Minerva Arnold
[1.5.1.8.1.1.2.2.1.2.9]
b. 24 Mar 1861 d. 11 Apr 1930
William Albert Smiley
b. Abt 1857 d. 1944
12
Stanton L Smiley
[1.5.1.8.1.1.2.2.1.2.9.1]
b. 19 Jan 1895 d. 2 May 1973
10
Louisa M Arnold
[1.5.1.8.1.1.2.2.1.3]
b. 10 Nov 1820
Augusta Adlington
b. Abt 1816
11
Joseph A Adlington
[1.5.1.8.1.1.2.2.1.3.1]
b. 12 Jan 1842 d. Bef 1952
11
Maria E Adlington
[1.5.1.8.1.1.2.2.1.3.2]
b. 20 Sep 1843 d. Bef 1953
11
Harriet Adlington
[1.5.1.8.1.1.2.2.1.3.3]
b. Sep 1848 d. Bef 1958
10
Sarah A Arnold
[1.5.1.8.1.1.2.2.1.4]
b. 23 Mar 1823 d. 3 Mar 1914
George C Wilder
b. Abt 1819
11
Rosina J Wilder
[1.5.1.8.1.1.2.2.1.4.1]
b. 11 Jun 1845 d. Bef 1850
11
Ella F Wilder
[1.5.1.8.1.1.2.2.1.4.2]
b. 28 Jul 1846 d. Bef 1956
10
Lucien J Arnold
[1.5.1.8.1.1.2.2.1.5]
b. 3 Mar 1826 d. 20 Aug 1887
10
Elizabeth Arnold
[1.5.1.8.1.1.2.2.1.6]
b. 7 Aug 1828
Loring Boyden
b. Aug 1817 d. Bef 1927
11
Charles L Boyden
[1.5.1.8.1.1.2.2.1.6.1]
b. 11 Feb 1847
11
Medora E Boyden
[1.5.1.8.1.1.2.2.1.6.2]
b. 28 Dec 1849 d. Bef 1959
11
Clara Stanton Boyden
[1.5.1.8.1.1.2.2.1.6.3]
b. May 1856 d. Bef 1966
10
Mary E Arnold
[1.5.1.8.1.1.2.2.1.7]
b. 16 May 1831
10
Alice A Arnold
[1.5.1.8.1.1.2.2.1.8]
b. 11 Aug 1834
+
Benjamin W Johnson
b. 29 Jan 1819
10
Helen M Arnold
[1.5.1.8.1.1.2.2.1.9]
b. 23 Jun 1837
10
Emily Boyden Arnold
[1.5.1.8.1.1.2.2.1.10]
b. 12 Mar 1840 d. 27 Aug 1888
Orlando Samuel Stetson
b. 25 Apr 1832 d. 31 May 1921
11
John Stetson
[1.5.1.8.1.1.2.2.1.10.1]
b. Abt 1861 d. Abt 1871
11
Florence Stetson
[1.5.1.8.1.1.2.2.1.10.2]
b. Abt 1863 d. Abt 1873
11
Orlando Samuel Stetson
[1.5.1.8.1.1.2.2.1.10.3]
b. 6 Aug 1877 d. Bef 1967
9
Nelson J Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.2]
b. 22 Jul 1797 d. 23 Jan 1855
Deborah Wheelock Morse
b. 27 Feb 1782 d. 27 Feb 1872
10
Arnold A Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.2.1]
b. 19 Oct 1822 d. 1 Dec 1824
10
Olive A Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.2.2]
b. 9 Jan 1824
Nathaniel Elliot
b. 25 Mar 1821
11
Edgar C Elliot
[1.5.1.8.1.1.2.2.2.2.1]
b. 9 Nov 1844 d. 16 Jun 1857
11
Hattie Oliva Elliott
[1.5.1.8.1.1.2.2.2.2.2]
b. 26 Jan 1853 d. 20 Jun 1876
George Willard Spaulding
b. 29 Jun 1843
12
Edgar Le Roy Spalding
[1.5.1.8.1.1.2.2.2.2.2.1]
b. 26 Sep 1874 [
=>
]
11
Ida A Elliot
[1.5.1.8.1.1.2.2.2.2.3]
b. 11 Mar 1847 d. 28 Aug 1847
11
Charles U Elliott
[1.5.1.8.1.1.2.2.2.2.4]
b. 11 Mar 1848
11
Charles N Elliot
[1.5.1.8.1.1.2.2.2.2.5]
b. 12 Mar 1849
+
Mattie Tyler
b. Abt 1851
11
Anna Augusta Elliott
[1.5.1.8.1.1.2.2.2.2.6]
b. 31 Jan 1851 d. 24 Feb 1875
Walter Edward Parker
b. 28 Sep 1847
12
Herbert Sumner Parker
[1.5.1.8.1.1.2.2.2.2.6.1]
b. 18 Oct 1874
11
Horace Jenckes Elliott
[1.5.1.8.1.1.2.2.2.2.7]
b. 25 Jan 1860
Bertha Simmons Foss
b. Abt 1862
12
Samuel Foss Elliott
[1.5.1.8.1.1.2.2.2.2.7.1]
b. Abt 1885
12
Charles Hendrick Elliott
[1.5.1.8.1.1.2.2.2.2.7.2]
b. 10 Feb 1886 d. 15 Aug 1886
10
Lydia Elizabeth Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.2.3]
b. 5 May 1828
William M Whitaker
b. 2 Dec 1824
11
Edward Stanley Whitaker
[1.5.1.8.1.1.2.2.2.3.1]
b. 19 Mar 1848 d. 1922
Mary Anna Walsh
b. 1849 d. 1 Jun 1880
12
Daughter Whitaker
[1.5.1.8.1.1.2.2.2.3.1.1]
b. 20 Apr 1874
12
Walter S Whitaker
[1.5.1.8.1.1.2.2.2.3.1.2]
b. Dec 1875
12
Daughter Whitaker
[1.5.1.8.1.1.2.2.2.3.1.3]
b. 13 Dec 1877 d. 13 Dec 1877
+
Mary Elizabeth Ware
b. 17 Feb 1848 d. 1 Oct 1926
11
Sidney Augustus Whitaker
[1.5.1.8.1.1.2.2.2.3.2]
b. 9 Feb 1850
11
Marcial Stewart Whitaker
[1.5.1.8.1.1.2.2.2.3.3]
b. 23 Nov 1854 d. 15 Jul 1914
10
Elias Morse Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.2.4]
b. 24 Dec 1826 d. 29 Oct 1892
Sarah Sweetland Arnold
b. 8 Sep 1828 d. Bef 1943
11
Nellie Beebe Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.2.4.1]
b. 19 Oct 1855
11
Ida Alice Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.2.4.2]
b. 10 Nov 1857
10
Andrew Nelson Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.2.5]
b. 22 Sep 1831 d. 13 Jan 1884
Lydia Hart Coggeshall
b. 14 Jul 1842 d. Bef 1953
11
Henry Nelson Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.2.5.1]
b. 10 Apr 1860 d. 14 Aug 1871
11
Edgar Burnside Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.2.5.2]
b. 24 Sep 1862 d. 29 Oct 1865
11
Lillian May Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.2.5.3]
b. 22 Dec 1864
+
Charles Harris Gorton
b. 7 Aug 1853
11
Edith Louise Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.2.5.4]
b. 27 Aug 1870 d. 25 Aug 1871
11
Hattie Olive Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.2.5.5]
b. 10 Jul 1873
+
Fred Lester Horton
b. 25 Jul 1869
11
William Herbert Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.2.5.6]
b. 23 Jun 1875
+
Mary Jane Heaslip
b. 25 Dec 1875
11
Daughter Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.2.5.7]
b. 13 Mar 1879
11
Rachel Louise Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.2.5.8]
b. 20 Mar 1879
10
Sarah E Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.2.6]
b. 11 Nov 1835 d. 22 Aug 1836
10
Ellen A Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.2.7]
b. 3 Jan 1838 d. 5 Dec 1838
10
Horace Adelbert Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.2.8]
b. 23 Sep 1841 d. 10 Oct 1889
Almira Arnold Scott
b. 11 Jun 1841 d. 8 Feb 1919
11
Clara Nettie Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.2.8.1]
b. 11 Dec 1860 d. 17 Aug 1862
11
Nelson Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.2.8.2]
b. 8 Oct 1862 d. Oct 1935
Helen Rayner Aldrich
b. 15 Sep 1864
12
Leland Aldrich Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.2.8.2.1]
b. 27 Apr 1886 d. 4 Oct 1919
12
Horace A Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.2.8.2.2]
b. 6 Jan 1890 d. 7 Jan 1890
10
Bartoa W Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.2.9]
b. 24 Oct 1845 d. 24 Jun 1846
9
George Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.3]
b. 15 Jun 1799 d. 12 Dec 1869
Abigail Farnum
b. 15 Jan 1797 d. 30 Jan 1822
10
William H Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.3.1]
b. 22 Dec 1823 d. 12 Nov 1877
Amey Ann Kent
b. Abt 1825
11
Walter I Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.3.1.1]
b. 2 Sep 1855
11
Frederic W Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.3.1.2]
b. 29 Oct 1856
11
Emma Frances Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.3.1.3]
b. 4 May 1858 d. 1 Apr 1941
Waldo Stephen Cook
b. 17 Sep 1857 d. 30 Dec 1927
12
Son Cook
[1.5.1.8.1.1.2.2.3.1.3.1]
b. 5 Jul 1879 d. 6 Jul 1879
12
Amy Jenckes Cook
[1.5.1.8.1.1.2.2.3.1.3.2]
b. 9 Jul 1880 d. 5 Jul 1979
12
Lucius Alonzo Cook
[1.5.1.8.1.1.2.2.3.1.3.3]
b. 6 Apr 1882 d. 28 Feb 1940
12
Maude Elaine Cook
[1.5.1.8.1.1.2.2.3.1.3.4]
b. 1 Apr 1885 d. 12 Feb 1985
12
Herbert Leonard Cook
[1.5.1.8.1.1.2.2.3.1.3.5]
b. 24 Jul 1889 d. 7 Aug 1919
12
Austin Harold Cook
[1.5.1.8.1.1.2.2.3.1.3.6]
b. 5 Nov 1891 d. 24 May 1972 [
=>
]
12
Sarah Elizabeth Cook
[1.5.1.8.1.1.2.2.3.1.3.7]
b. 23 Oct 1893 d. 21 Dec 1932
12
William Stanton Cook
[1.5.1.8.1.1.2.2.3.1.3.8]
b. 10 Apr 1895 d. 4 Jun 1945
12
Fred Russell Cook
[1.5.1.8.1.1.2.2.3.1.3.9]
b. 3 Jan 1899 d. 15 Mar 1932
11
Sarah Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.3.1.4]
b. 17 Aug 1859 d. 10 Apr 1925
+
George R Smith
b. Abt 1861
10
Edwin Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.3.2]
b. 9 Jan 1826 d. 12 Jun 1895
Mary Adaline Johnson
b. 21 Oct 1829 d. 11 Nov 1851
11
Joseph Edwin Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.3.2.1]
b. 18 Aug 1851 d. 6 Jan 1910
Frederica Clark
b. 12 Dec 1850 d. 25 Sep 1940
12
Robert Johnson Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.3.2.1.1]
b. 16 Dec 1873 d. 11 Feb 1929
12
Mary Church Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.3.2.1.2]
b. 13 Feb 1876 [
=>
]
12
Frederick L Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.3.2.1.3]
b. 4 Apr 1877
12
Josephine Densay Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.3.2.1.4]
b. Abt 1879 d. 24 Nov 1883
Harriet Eliza Morse
b. 5 Jan 1824 d. 31 Jan 1871
11
Latimer Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.3.2.2]
b. 8 Aug 1860
11
Harriet Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.3.2.3]
b. 1862 d. 21 Aug 1909
11
Adaline Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.3.2.4]
b. 1864
11
Edwin Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.3.2.5]
b. 1866
Martha Thornton
b. 12 Jun 1851 d. 4 Oct 1933
11
Edwin Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.3.2.6]
b. Abt 1874
10
George W Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.3.3]
b. 17 Aug 1829 d. 27 Jan 1913
Martha Ann Hunt
b. Abt 1831
11
Frank Herbert Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.3.3.1]
b. 26 Jan 1860
+
Smith
b. Abt 1862
+
Mabel Rathburn
b. Abt 1862
11
Waldo Warner Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.3.3.2]
b. 4 Oct 1861
11
Clara Hunt Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.3.3.3]
b. 1 Jan 1865
11
Earl Stanton Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.3.3.4]
b. 9 May 1872
+
Grace L Rankin
b. Abt 1874
10
Leander Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.3.4]
b. 30 Jan 1832 d. 11 Apr 1861
+
Clarissa Ann Jenette Whipple
b. 8 May 1836
10
Ferdinand Lawton Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.3.5]
b. 19 Jan 1834
Amelia Melissa Whipple
b. 3 Jun 1834
11
Daughter Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.3.5.1]
b. 21 Oct 1858
11
Charles F Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.3.5.2]
b. Abt 1860 d. 15 Jan 1937
11
Oscar I Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.3.5.3]
b. Abt 1862
+
Ida E Lynch Morey
b. Abt 1864
11
Jessie F Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.3.5.4]
b. Abt 1870 d. 25 Mar 1874
11
Mabel Viola Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.3.5.5]
b. 21 May 1878 d. 1918
11
Medora A Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.3.5.6]
b. Abt 1880
+
Jesse Albert Carpenter
b. Abt 1878
11
George Washington Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.3.5.7]
b. Abt 1882
+
Elizabeth Kathleen Murray
b. Abt 1884
10
Sarah E Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.3.6]
b. 20 Feb 1837 d. 10 Apr 1860
9
Wheaton Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.4]
b. 26 Sep 1801 d. 4 Sep 1803
9
Barton J Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.5]
b. 8 Jan 1804 d. 16 Jun 1834
Amelia Cook
b. 13 Feb 1808 d. 21 May 1838
10
Harriet Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.5.1]
b. 26 Aug 1832 d. 1 Jun 1834
10
Frederick Barton Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.5.2]
b. 15 Jan 1834 d. 11 Feb 1835
9
Charles Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.6]
b. 28 Jul 1806 d. 30 Aug 1861
Louisa Cook
b. 15 Nov 1809 d. 6 Oct 1894
10
Henry C Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.6.1]
b. Abt 1831
+
Helen Frances Mowry
b. Abt 1833 d. 29 Aug 1894
10
Allen Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.6.2]
b. Abt 1833 d. 10 Jul 1907
Sarah Louisa Thayer
b. 17 Mar 1838
11
Isabel F Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.6.2.1]
b. 7 May 1861 d. 21 May 1863
11
Charles Allen Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.6.2.2]
b. 27 May 1869
10
Fred B Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.6.3]
b. Abt 1833
10
Estelle Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.6.4]
b. Abt 1837
+
Waldo Slocomb
b. Abt 1835
10
Lucy A Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.6.5]
b. Abt 1839
9
Albert Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.7]
b. 13 Feb 1809
Elizabeth Maria Pratt
b. 6 Jul 1815
10
Levilla Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.7.1]
b. 1840
10
Mary Deloss Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.7.2]
b. 22 May 1842 d. 20 Aug 1843
10
Albert Oscar Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.7.3]
b. 18 May 1846 d. 30 Mar 1866
10
Henry Pratt Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.7.4]
b. 27 Sep 1849 d. 13 May 1855
10
Charles Fremont Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.7.5]
b. 19 Feb 1854 d. 11 Mar 1896
10
Emma Frances Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.7.6]
b. 3 Nov 1858 d. 15 Aug 1860
9
Mary Ann Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.8]
b. 2 Jul 1811 d. 24 Nov 1836
+
Christopher Robinson
b. 15 May 1806
9
Julia E Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.9]
b. 31 Jul 1813 d. 31 Dec 1872
Aaron Rathbone
b. 24 Apr 1804 d. 24 Mar 1854
10
Oscar J Rathbone
[1.5.1.8.1.1.2.2.9.1]
b. 12 Mar 1832
+
Israel White
b. Abt 1809
9
William Augustus Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.10]
b. 12 Jun 1815 d. 19 Aug 1899
Lucilla Laura Tourtellot Young
b. 5 Sep 1816 d. 8 Feb 1843
10
Earl Francis Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.10.1]
b. 20 Jul 1838 d. 28 Apr 1853
10
Leland Delos Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.10.2]
b. 27 Nov 1839 d. 25 Aug 1872
+
Arabella Holder
b. Abt 1841
Adelia Crooks
b. 10 Sep 1832 d. 9 Apr 1909
10
Mary Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.10.3]
b. Abt 1856
10
Barton C Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.10.4]
b. 27 Aug 1857 d. 13 Mar 1897
10
Marianna Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.10.5]
b. 23 Nov 1859 d. 4 Mar 1951
George P Cooke
b. Abt 1857 d. 1914
11
Allan Jencks Cooke
[1.5.1.8.1.1.2.2.10.5.1]
b. 6 Dec 1884 d. 1942
11
Guenn Cooke
[1.5.1.8.1.1.2.2.10.5.2]
b. 4 Jul 1887
11
Mildred A Cooke
[1.5.1.8.1.1.2.2.10.5.3]
b. 10 Aug 1890
11
Mary J Cooke
[1.5.1.8.1.1.2.2.10.5.4]
b. 14 Nov 1894
10
Grace A Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.10.6]
b. 23 Dec 1866
+
George H Dame
b. Abt 1864
10
Florence E Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.10.7]
b. 14 Mar 1863
John Bradford Spencer
b. Abt 1861
11
Bradford Jenckes Spencer
[1.5.1.8.1.1.2.2.10.7.1]
b. 19 Nov 1890
+
Marion L Moule
b. 22 Feb 1895
10
William Francis Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.10.8]
b. 1 Jul 1875 d. 1 Oct 1875
9
Harriet Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.11]
b. 5 Aug 1819 d. 29 Sep 1820
9
Horace Aldrich Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.12]
b. 8 Apr 1822 d. 24 Apr 1840
9
Edwin Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.13]
b. 9 Jan 1826 d. 12 Jun 1895
Mary Adaline Johnson
b. 21 Oct 1829 d. 11 Nov 1851
10
Joseph Edwin Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.13.1]
b. 18 Aug 1851 d. 6 Jan 1910
Frederica Clark
b. 12 Dec 1850 d. 25 Sep 1940
11
Robert Johnson Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.13.1.1]
b. 16 Dec 1873 d. 11 Feb 1929
11
Mary Church Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.13.1.2]
b. 13 Feb 1876
Isaac Butts Merriman
b. 8 Oct 1874
12
Marie Merriman
[1.5.1.8.1.1.2.2.13.1.2.1]
b. 1902
12
Isaac B Merriman
[1.5.1.8.1.1.2.2.13.1.2.2]
b. 1903
11
Frederick L Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.13.1.3]
b. 4 Apr 1877
11
Josephine Densay Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.13.1.4]
b. Abt 1879 d. 24 Nov 1883
Harriet Eliza Morse
b. 5 Jan 1824 d. 31 Jan 1871
10
Latimer Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.13.2]
b. 8 Aug 1860
10
Harriet Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.13.3]
b. 1862 d. 21 Aug 1909
10
Adaline Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.13.4]
b. 1864
10
Edwin Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.13.5]
b. 1866
Martha Thornton
b. 12 Jun 1851 d. 4 Oct 1933
10
Edwin Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.2.13.6]
b. Abt 1874
8
Mary Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.3]
b. 24 Nov 1772 d. 4 Jan 1818
8
Luke Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.4]
b. 1774 d. 13 Oct 1848
Robey Arnold
b. 2 Oct 1778 d. 22 Aug 1875
9
Lydia Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.4.1]
b. 1800 d. 21 Jul 1876
9
Luke Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.4.2]
b. 1803 d. 15 Mar 1843
Betsey Ballou
b. 21 Oct 1799 d. 25 Sep 1870
10
Arnold Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.4.2.1]
b. 17 Aug 1832 d. 29 Jul 1846
10
Marcien Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.4.2.2]
b. 23 Jun 1834 d. 15 Mar 1912
Amelia Marcon Bates
b. 22 May 1838 d. 12 Apr 1916
11
Anna Amelia Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.4.2.2.1]
b. 30 Oct 1860
Louis Harding
b. Abt 1859
12
Louis Harding
[1.5.1.8.1.1.2.4.2.2.1.1]
b. Abt 1880
12
Lawrence Harding
[1.5.1.8.1.1.2.4.2.2.1.2]
b. Abt 1882
12
Nanette Harding
[1.5.1.8.1.1.2.4.2.2.1.3]
b. Abt 1884
12
Lucy Harding
[1.5.1.8.1.1.2.4.2.2.1.4]
b. Abt 1886
12
Amelia Harding
[1.5.1.8.1.1.2.4.2.2.1.5]
b. Abt 1888
11
Lawrence Bates Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.4.2.2.2]
b. 23 Mar 1867 d. 9 Mar 1922
Alice Child
b. 2 Jan 1861 d. 23 Dec 1945
12
Marcian Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.4.2.2.2.1]
b. 5 Apr 1900
10
Asbert Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.4.2.3]
b. 5 Jul 1836
10
Celia Maria Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.4.2.4]
b. 8 Jun 1838
Joseph P Pillsbury
b. Abt 1836 d. 28 Oct 1877
11
Sherman J Pillsbury
[1.5.1.8.1.1.2.4.2.4.1]
b. 23 Oct 1863
11
Bertha Pillsbury
[1.5.1.8.1.1.2.4.2.4.2]
b. 16 Jul 1865
10
Ella Amelia Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.4.2.5]
b. 22 Sep 1841
8
Diana Jenckes
[1.5.1.8.1.1.2.5]
b. 1 Jan 1776 d. 11 Aug 1847
6
Phoebe Tingley
[1.5.1.8.1.2]
b. 12 Dec 1732 d. 16 Feb 1807
6
Phillis Tingley
[1.5.1.8.1.3]
b. 30 Dec 1734
6
Elizabeth Tingley
[1.5.1.8.1.4]
b. 20 Nov 1736
6
Rebekah Tingley
[1.5.1.8.1.5]
b. 4 Feb 1739
6
Anna Tingley
[1.5.1.8.1.6]
b. 13 Nov 1741
6
Sarah Tingely
[1.5.1.8.1.7]
b. 9 Sep 1744
6
Ephraim Tingley
[1.5.1.8.1.8]
b. 12 Jul 1746
5
James Birchard
[1.5.1.8.2]
b. 3 May 1699 bur. 1782
5
Sarah Birchard
[1.5.1.8.3]
b. 10 Jul 1701 d. 15 Aug 1701
5
Matthew Birchard
[1.5.1.8.4]
b. 5 Dec 1702 d. 18 Jan 1726
+
Ruth Hartshorn
b. 12 May 1706 d. Aft 1750
5
Phebe Birchard
[1.5.1.8.5]
b. Oct 1705 d. 13 Mar 1791
5
Sarah Birchard
[1.5.1.8.6]
b. 9 Oct 1711 d. 13 Mar 1791
5
Rebecca Birchard
[1.5.1.8.7]
b. 1717 d. 1719
5
Daniel Birchard
[1.5.1.8.8]
b. 9 May 1718 d. 1780
4
Abigail Birchard
[1.5.1.9]
b. 12 Nov 1667 d. 23 Aug 1741
4
Thomas Birchard
[1.5.1.10]
b. Jan 1669 d. 21 Mar 1741
4
John Birchard
[1.5.1.11]
b. Feb 1671 d. 30 Jun 1735
4
Joseph Birchard
[1.5.1.12]
b. Feb 1673 d. 9 Mar 1755
4
Benjamin Birchard
[1.5.1.13]
b. Dec 1675 d. Dec 1675
4
Mary Birchard
[1.5.1.14]
b. Jun 1677 d. Aft 11 Apr 1758
Jonathan Hartshorn
b. 14 May 1677 d. 1 Nov 1751
5
Mary Hartshorn
[1.5.1.14.1]
b. Jun 1701 d. 1752
5
Ruth Hartshorn
[1.5.1.14.2]
b. 31 Dec 1703 d. 1759
5
Abigail Hartshorn
[1.5.1.14.3]
b. 1 Feb 1705 d. 1 May 1789
5
Ruth Hartshorn
[1.5.1.14.4]
b. 12 May 1706 d. Aft 1750
+
Matthew Birchard
b. 5 Dec 1702 d. 18 Jan 1726
James Dickinson
b. 31 Dec 1705 d. 27 Jun 1756
6
Mary Dickinson
[1.5.1.14.4.1]
b. 20 Feb 1728
6
Submit Dickinson
[1.5.1.14.4.2]
b. 29 Jun 1731 d. 1788
6
Ruth Dickson
[1.5.1.14.4.3]
b. 3 Mar 1734
6
James Dickinson
[1.5.1.14.4.4]
b. 1 Aug 1736 d. Aft 1775
6
Jonathan Dickinson
[1.5.1.14.4.5]
b. 18 Nov 1738 d. 16 Oct 1762
Abigail Whipple
b. 30 Jan 1729 d. 21 Apr 1806
7
Mary Dickinson
[1.5.1.14.4.5.1]
b. 25 Dec 1758 d. 5 Mar 1759
7
Jonathan Dickinson
[1.5.1.14.4.5.2]
b. 30 Sep 1760
7
Mary Dickinson
[1.5.1.14.4.5.3]
b. Mar 1762 d. May 1850
6
Noah Dickinson
[1.5.1.14.4.6]
b. 14 Mar 1741 d. 16 Jan 1828
6
Mathew Dickinson
[1.5.1.14.4.7]
b. 14 Apr 1743 d. 21 Sep 1762
6
Ruth Dickinson
[1.5.1.14.4.8]
b. 29 Jul 1745 d. 22 Nov 1834
6
Love Dickinson
[1.5.1.14.4.9]
b. 2 Jun 1750
5
Hannah Hartshorn
[1.5.1.14.5]
b. 2 Dec 1709 d. 21 Jun 1779
5
Lydia Hartshorn
[1.5.1.14.6]
b. 12 Apr 1711 d. 10 Dec 1726
5
John Hartshorn
[1.5.1.14.7]
b. 19 Nov 1715 d. Aft 1750
5
Jonathan Hartshorn
[1.5.1.14.8]
b. 25 Oct 1717 d. 1796
5
Zerviah Hartshorn
[1.5.1.14.9]
b. 27 Jan 1719 d. 1775
3
Mary Andrews
[1.5.2]
b. 1 Nov 1631 d. Mar 1661
3
John Andrews
[1.5.3]
b. Abt 1635
3
Sarah Andrews
[1.5.4]
b. 1642 d. 12 Jun 1702