Home Page
|
What's New
|
Photos
|
Histories
|
Headstones
|
Reports
|
Surnames
Search
First Name:
Last Name:
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Suomalainen
Svenska
Agnes Sporne
1510 - 1564 (54 years)
Submit Photo / Document
Individual
Descendants
Relationship
Timeline
Submit Photo / Doc
Worksheet
Family
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Agnes Sporne
[1]
b. 1510 d. 5 Jan 1564
George Peryente
b. 1505 d. 25 Apr 1556
2
Elizabeth Styles Peryente
[1.1]
b. 27 Jun 1536 d. 30 Jun 1580
Lord Thomas Townsend
b. 1 Oct 1534 d. 12 Jun 1591
3
Rodger Townsend
[1.1.1]
b. 5 Jul 1563 d. 22 Jan 1573
3
Thomas Townsend
[1.1.2]
b. 25 Sep 1566 d. 2 Jan 1567
3
Sir Henry Townsend
[1.1.3]
b. 31 May 1568 d. 22 Aug 1625
Margaret Forthe
b. 1570 d. 23 Jun 1596
4
Robert Townsend
[1.1.3.1]
b. 18 Jun 1591 d. 22 Dec 1677
4
Arthur Townsend
[1.1.3.2]
b. 16 Nov 1593 d. 1605
4
Thomas Townsend
[1.1.3.3]
b. 8 Jan 1594 d. 22 Dec 1677
Mary Newgate
b. 1598 d. 28 Feb 1692
5
Lydia Townsend
[1.1.3.3.1]
b. 1618 d. 2 Nov 1661
Lawrence Copeland
c. 24 May 1614 d. 11 Feb 1660
6
Lydia Copeland
[1.1.3.3.1.1]
b. 27 Mar 1642 d. 8 May 1727
Joseph White
b. 17 Dec 1662 d. 28 Oct 1757
7
Mary White
[1.1.3.3.1.1.1]
b. 27 Feb 1682 d. 1701
7
Captain Joseph White
[1.1.3.3.1.1.2]
b. 19 Oct 1683 d. 15 Jun 1737
Prudence Smith
b. 19 Jul 1691 d. 5 Apr 1785
8
Joseph White
[1.1.3.3.1.1.2.1]
b. 22 Sep 1712 d. 12 Mar 1788
Judeth Clarke
b. 1711 d. 3 Feb 1794
9
Sarah White
[1.1.3.3.1.1.2.1.1]
b. 1735 d. 1747
9
Tryal White
[1.1.3.3.1.1.2.1.2]
b. 8 May 1737 d. 14 Jun 1814
Lieutenant Abner Taft
b. 28 Dec 1736 d. 30 May 1809
10
Oliver Taft
[1.1.3.3.1.1.2.1.2.1]
b. 1 May 1758 d. 16 Jul 1775
10
Moses Taft
[1.1.3.3.1.1.2.1.2.2]
b. 29 Sep 1760 d. 4 Dec 1848
Judith Cummings
b. 26 Nov 1766 d. 26 Nov 1816
11
Nancy Taft
[1.1.3.3.1.1.2.1.2.2.1]
b. 10 Mar 1787
11
Samuel Taft
[1.1.3.3.1.1.2.1.2.2.2]
b. 24 Sep 1790 d. 11 Oct 1863
11
Lucy Taft
[1.1.3.3.1.1.2.1.2.2.3]
b. 24 Apr 1795 d. 21 Jun 1847
11
Newell Taft
[1.1.3.3.1.1.2.1.2.2.4]
b. 28 Jul 1804 d. 4 Nov 1873
Hannah G Taft
b. 18 May 1802 d. 8 Jan 1843
12
Albert Taft
[1.1.3.3.1.1.2.1.2.2.4.1]
b. 28 Aug 1823 d. Aft 1874 [
=>
]
12
Marcy Taft
[1.1.3.3.1.1.2.1.2.2.4.2]
b. Mar 1829 d. 12 Apr 1830
12
Charles M Taft
[1.1.3.3.1.1.2.1.2.2.4.3]
b. Jan 1843 d. 7 Dec 1843
11
Sylvia Taft
[1.1.3.3.1.1.2.1.2.2.5]
b. 23 Aug 1810 d. 3 Aug 1816
10
Mary Taft
[1.1.3.3.1.1.2.1.2.3]
b. 12 Oct 1767 d. 18 Aug 1775
10
Webb Taft
[1.1.3.3.1.1.2.1.2.4]
b. 26 Mar 1772 d. 21 Apr 1842
Lucy Taft
b. 9 Jun 1774 d. 14 Mar 1846
11
Lucinda Taft
[1.1.3.3.1.1.2.1.2.4.1]
b. 22 Nov 1793
11
Jason Taft
[1.1.3.3.1.1.2.1.2.4.2]
b. 5 Jun 1796 d. 25 Oct 1861
10
Trial T Taft
[1.1.3.3.1.1.2.1.2.5]
b. 13 Apr 1777 d. 18 Aug 1815
9
Lois White
[1.1.3.3.1.1.2.1.3]
b. 25 Aug 1739 d. 7 Jan 1806
Edward Seagrave
b. Abt 1722 d. 20 May 1793
10
John Seagrave
[1.1.3.3.1.1.2.1.3.1]
b. 6 Nov 1757 d. 3 Feb 1842
10
Lois Seagrave
[1.1.3.3.1.1.2.1.3.2]
b. 5 Nov 1759 d. 8 Mar 1819
10
Sarah Sally Seagrave
[1.1.3.3.1.1.2.1.3.3]
b. 31 Dec 1760 d. 12 May 1851
10
Joseph Seagrave
[1.1.3.3.1.1.2.1.3.4]
b. 21 Dec 1761 d. 30 Aug 1830
10
Mary Seagrave
[1.1.3.3.1.1.2.1.3.5]
b. 1 Apr 1764 d. 1777
10
Bezaleel Seagrave
[1.1.3.3.1.1.2.1.3.6]
b. 14 Dec 1766 d. 1 Aug 1830
10
Caleb Seagrave
[1.1.3.3.1.1.2.1.3.7]
b. 14 Mar 1771 d. 22 Sep 1836
10
Josiah Seagrave
[1.1.3.3.1.1.2.1.3.8]
b. 14 Oct 1773 d. 20 Mar 1855
Lois Taft
b. 27 Aug 1780 d. 27 Apr 1854
11
Mary Ann Seagrave
[1.1.3.3.1.1.2.1.3.8.1]
b. 17 Nov 1799 d. 10 Feb 1825
11
Jacob Taft Seagraves
[1.1.3.3.1.1.2.1.3.8.2]
b. 8 Apr 1802 d. 24 Sep 1870
11
Henrietta Frost Seagrave
[1.1.3.3.1.1.2.1.3.8.3]
b. 1 Dec 1803 d. 1 Jun 1823
11
Waity Grant Seagrave
[1.1.3.3.1.1.2.1.3.8.4]
b. 23 Sep 1805 d. 27 Jan 1859
11
Edward Seagrave
[1.1.3.3.1.1.2.1.3.8.5]
b. 3 Sep 1807 d. 15 Feb 1873
11
Lois Taft Seagrave
[1.1.3.3.1.1.2.1.3.8.6]
b. 13 Apr 1809 d. 19 Mar 1853
11
Josiah Seagrave, Jr
[1.1.3.3.1.1.2.1.3.8.7]
b. 24 May 1811 d. 21 Jul 1861
11
Malvina Seagrave
[1.1.3.3.1.1.2.1.3.8.8]
b. 2 Apr 1813 d. 16 Dec 1823
11
Caleb Seagrave
[1.1.3.3.1.1.2.1.3.8.9]
b. 8 Feb 1815 d. 14 Nov 1823
11
Son Seagrave
[1.1.3.3.1.1.2.1.3.8.10]
b. 3 May 1817 d. 3 May 1817
11
Daughter Seagrave
[1.1.3.3.1.1.2.1.3.8.11]
b. 3 May 1817 d. 3 May 1817
11
Esborn Seagrave
[1.1.3.3.1.1.2.1.3.8.12]
b. 28 Dec 1818 d. 27 Oct 1856
11
George Augustus Seagrave
[1.1.3.3.1.1.2.1.3.8.13]
b. 6 Jan 1823 d. 15 Nov 1884
10
Edward Seagrave
[1.1.3.3.1.1.2.1.3.9]
b. 14 Oct 1773 d. 31 Jul 1797
10
Olive Seagrave
[1.1.3.3.1.1.2.1.3.10]
b. 17 Apr 1779 d. 1868
10
Samuel Seagraves
[1.1.3.3.1.1.2.1.3.11]
b. 3 Feb 1782 d. 4 Feb 1855
9
Joseph White
[1.1.3.3.1.1.2.1.4]
b. 1744 d. 1747
9
Judith White
[1.1.3.3.1.1.2.1.5]
b. 1746 d. 1747
9
Amos White
[1.1.3.3.1.1.2.1.6]
b. 1748 d. 1782
9
Joel White
[1.1.3.3.1.1.2.1.7]
b. 1751 d. 1835
9
Jesse White
[1.1.3.3.1.1.2.1.8]
b. 1754 d. 1830
9
Edward White
[1.1.3.3.1.1.2.1.9]
b. 1756 d. 1756
9
Abner White
[1.1.3.3.1.1.2.1.10]
b. 1758 d. 1758
9
Moses White
[1.1.3.3.1.1.2.1.11]
b. 1759 d. 1759
9
Eunice White
[1.1.3.3.1.1.2.1.12]
b. 1 Nov 1741 d. 3 Apr 1825
8
Peter White
[1.1.3.3.1.1.2.2]
b. 6 Dec 1714 d. 8 May 1782
Jemima Taft
b. 1 Apr 1713 d. 14 Oct 1787
9
Joseph White
[1.1.3.3.1.1.2.2.1]
b. 25 Jun 1738 d. 1805
9
Bethaih White
[1.1.3.3.1.1.2.2.2]
b. 1 Mar 1740 d. 1809
9
Elisabeth White
[1.1.3.3.1.1.2.2.3]
b. 13 Dec 1743
9
Peter White
[1.1.3.3.1.1.2.2.4]
b. 1746 d. 2 Dec 1821
9
Jemima White
[1.1.3.3.1.1.2.2.5]
b. Abt 1754 d. Abt 1782
9
Nathan White
[1.1.3.3.1.1.2.2.6]
b. 10 Jan 1755 d. 21 Jan 1828
8
Aaron White
[1.1.3.3.1.1.2.3]
b. 22 May 1717 d. Abt 1760
+
Susanah Benson
b. 2 Aug 1721 d. Aft 1750
8
Moses White
[1.1.3.3.1.1.2.4]
b. 31 Aug 1721
Abigail Holbrook
b. Abt 1721 d. 1787
9
Stephen White
[1.1.3.3.1.1.2.4.1]
b. 22 Sep 1754
9
Moses White
[1.1.3.3.1.1.2.4.2]
b. 24 Jul 1751
9
Abner White
[1.1.3.3.1.1.2.4.3]
b. 27 May 1753
8
Abigail White
[1.1.3.3.1.1.2.5]
b. 27 Jan 1723 d. 4 May 1751
Benoni Benson
b. 18 Jul 1724 d. 10 Jan 1806
9
Stephen Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1]
b. 15 Jul 1742 d. 30 Jul 1823
Mary Holbrook
b. 15 Jul 1745 d. 1849
10
Ichabod Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.1]
b. 30 Dec 1764 d. Aug 1794
Polly Herrick
b. 16 Aug 1763 d. 4 Oct 1847
11
Alonzo Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.1.1]
b. 6 Jan 1794 d. 4 Jun 1881
Abigail Johnston
b. 30 Aug 1795 d. 29 Feb 1880
12
Eliza Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.1.1.1]
b. 10 Nov 1820 d. 11 Oct 1846 [
=>
]
12
Alma Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.1.1.2]
b. 10 Sep 1821 d. 22 Jun 1921 [
=>
]
12
Lyman Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.1.1.3]
b. 10 Dec 1822 d. 18 Feb 1917 [
=>
]
12
Ichabod Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.1.1.4]
b. 19 Dec 1823 d. 22 Sep 1901
12
Alonzo Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.1.1.5]
b. 2 May 1826 d. 16 Nov 1876
12
Son Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.1.1.6]
b. 14 Jun 1827 d. 28 Jul 1827
12
Harvey Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.1.1.7]
b. 14 Jul 1828 d. 3 Jun 1864
12
Gaylord S Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.1.1.8]
b. 28 Sep 1829 d. 18 Jul 1918
12
Abbie J Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.1.1.9]
b. 22 Jan 1831
12
Lavantia E Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.1.1.10]
b. 4 Oct 1832 [
=>
]
12
Orson Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.1.1.11]
b. 18 Mar 1835 d. 30 Nov 1859
12
Mary Louise Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.1.1.12]
b. 7 Sep 1837 d. 12 Aug 1870 [
=>
]
10
Elkanah Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2]
b. 21 Feb 1766 d. 8 Mar 1844
Deobrah Wheelock
b. 17 Dec 1765 d. 3 Aug 1846
11
Samuel Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.1]
b. 21 May 1791
Mary Van Liew
b. 8 Jul 1797 d. 22 Apr 1859
12
William Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.1.1]
b. 18 Dec 1817
12
Emily Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.1.2]
b. 18 Dec 1817
12
Alzina Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.1.3]
b. 8 Nov 1819 d. 29 Mar 1867
12
Augustus Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.1.4]
b. 10 Feb 1822
12
Phila Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.1.5]
b. 8 Mar 1824 [
=>
]
12
Nathan S Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.1.6]
b. 17 Sep 1826 d. 1869 [
=>
]
12
James Mapes Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.1.7]
b. 12 Jun 1828 d. 11 Oct 1907 [
=>
]
12
Montgomery Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.1.8]
b. Abt 1833
12
Mary Ellen Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.1.9]
b. Abt 1839
11
Chloe Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.2]
b. 6 Jan 1793 d. 1882
Lewis Smith
b. Abt 1790
12
Mary Smith
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.2.1]
b. Abt 1813 d. 1913
12
Sidney Smith
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.2.2]
b. 29 Jan 1815 d. 10 Sep 1900 [
=>
]
12
William Smith
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.2.3]
b. Abt 1817
12
Lewis Smith
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.2.4]
b. Abt 1820
12
Stephen Smith
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.2.5]
b. 19 Feb 1823 d. 26 Aug 1922 [
=>
]
12
Job Lewis Smith
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.2.6]
b. 15 Oct 1827 d. 9 Jun 1897
11
Adolphus Willard Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.3]
b. 17 Dec 1795 d. 18 May 1878
Hannah Vermilyea
b. 1796 d. 28 Jun 1886
12
Edward Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.3.1]
b. 1824
12
Bryon L Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.3.2]
b. 25 Dec 1825 d. 23 Oct 1912 [
=>
]
12
Lewis Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.3.3]
b. Abt 1827
12
Elizabeth Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.3.4]
b. Abt 1829
12
Ellen Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.3.5]
b. Abt 1831
12
John Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.3.6]
b. Abt 1833
12
Henry Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.3.7]
b. Abt 1835
12
Jane H Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.3.8]
b. Abt 1837
12
Frank Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.3.9]
b. Abt 1839
11
Eliza Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.4]
b. 9 Mar 1798 d. 13 Nov 1817
+
James Miller
b. Abt 1795
11
Leonard Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.5]
b. 7 Apr 1800 d. 7 Sep 1877
Ruth Ann Reynolds
b. 23 Jul 1805 d. 2 Feb 1853
12
Elisha Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.5.1]
b. 1829 [
=>
]
12
William R Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.5.2]
b. 1831 d. 26 Feb 1889 [
=>
]
12
John Thompson Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.5.3]
b. 25 May 1833 d. 2 Apr 1914 [
=>
]
12
Emory J Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.5.4]
b. Jul 1836 d. 8 Mar 1926 [
=>
]
12
Finley E Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.5.5]
b. Abt 1841 [
=>
]
Hannah Sherman
12
Mary Isabelle Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.5.6]
b. 7 Jun 1853 d. 9 Dec 1935 [
=>
]
11
Phila Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.6]
b. 27 Jul 1802
Charles Warner
b. Abt 1800
12
Susan Warner
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.6.1]
b. 1828
12
Mary Warner
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.6.2]
b. 1830
12
Harriet Warner
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.6.3]
b. 1832
11
Calista Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.7]
b. 2 Jun 1804 d. 15 Sep 1882
Jacob Conklin
b. 19 Sep 1798 d. 1 Nov 1884
12
Sarah Conklin
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.7.1]
b. 1828
12
Edward Conklin
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.7.2]
b. Abt 1828
12
Sory Ann Conklin
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.7.3]
b. 1831 d. 7 Feb 1832
12
Benson Conklin
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.7.4]
b. May 1833 [
=>
]
12
John Conklin
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.7.5]
b. 1835 d. 25 Oct 1835
12
Maria Conklin
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.7.6]
b. 1837 d. 1850
12
Daughter Conklin
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.7.7]
b. 1840 d. 1840
12
Eugene Conklin
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.7.8]
b. 1841 d. 14 Apr 1912 [
=>
]
12
Daughter Conklin
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.7.9]
b. 1843 d. 3 Mar 1843
12
Lewis Smith Conklin
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.7.10]
b. Nov 1845 d. 28 Feb 1905 [
=>
]
12
Annette Conklin
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.7.11]
b. 1848 d. 22 Jun 1848
11
Ruth Wheelock Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.8]
b. 21 Sep 1807
William J Vermilyea
b. 7 Jul 1803 d. 30 Jun 1879
12
Francis Arvilla Vermilyea
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.8.1]
b. 19 Apr 1830 d. 19 Nov 1915 [
=>
]
12
Emily Benson Vermilyea
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.8.2]
b. 6 Dec 1831 d. Jun 1902 [
=>
]
12
Sidney Smith Vermilyea
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.8.3]
b. 27 Oct 1835 d. 22 Dec 1929 [
=>
]
12
Elkanah Benson Vermilyea
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.8.4]
b. 9 Sep 1837 d. 31 May 1838
12
Chauncey Vermilyea
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.8.5]
b. 25 Mar 1839 d. 16 Jun 1863
12
Eliza Prudence Vermilyea
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.8.6]
b. 4 Apr 1842 d. 1923 [
=>
]
12
John Benson Vermilyea
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.8.7]
b. 26 May 1844
12
Albert Gallatin Vermilyea
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.8.8]
b. 15 Sep 1846 [
=>
]
11
Sarah Elizabeth Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.9]
b. 1 Jul 1809 d. 20 Jul 1888
Leicester Dodge
b. 28 Apr 1808 d. 5 Sep 1843
12
Ermina P Dodge
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.9.1]
b. 14 Feb 1831
12
Henry Benson Dodge
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.9.2]
b. 3 Oct 1832 d. 16 Feb 1914 [
=>
]
12
Flora Elizabeth Dodge
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.9.3]
b. 6 Nov 1834
12
Sarah Janette Dodge
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.9.4]
b. 20 Sep 1836
12
Calista Augusta Dodge
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.9.5]
b. 23 Nov 1838 d. 29 Aug 1884
12
Caroline Emelia Dodge
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.9.6]
b. 30 Aug 1841 d. 7 Dec 1913 [
=>
]
12
Lester Lewis Dodge
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.2.9.7]
b. 30 Oct 1843
10
Esther Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.3]
b. 8 Dec 1768 d. 31 Mar 1855
Isaac Staples
b. 9 Mar 1742 d. 29 May 1848
11
Esther Staples
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.3.1]
b. Abt 1790 d. 17 May 1878
11
Abraham Staples
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.3.2]
b. 12 Mar 1792 d. 5 Sep 1881
11
Scammel Staples
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.3.3]
b. 29 Dec 1798 d. 5 Apr 1883
11
Warren Staples
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.3.4]
b. 17 Jan 1802
11
Evaline Staples
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.3.5]
b. 11 Aug 1807 d. 2 Oct 1858
10
Ezekial Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.4]
b. 13 Mar 1770
10
Phila Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.5]
b. 23 Feb 1772
Phineas Tyler
b. 14 Feb 1765 d. 21 Jan 1847
11
Daniel Tyler
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.5.1]
b. 2 Aug 1791
11
Phila Tyler
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.5.2]
b. Abt 1793
11
Mary Tyler
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.5.3]
b. 30 Mar 1794 d. 5 Aug 1885
Captain Henry Austin
b. 30 Jan 1782 d. 23 Jan 1852
12
Mary Austin
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.5.3.1]
b. 2 Aug 1815 d. 1832
12
Emily Austin
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.5.3.2]
b. 11 Nov 1817 d. 28 Jan 1860
12
Harriet Austin
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.5.3.3]
b. 23 Nov 1819 d. 25 Feb 1858
12
Edward Taylor Austin
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.5.3.4]
b. 26 Jul 1822
12
John Thompson Austin
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.5.3.5]
b. 13 Jun 1824 d. 26 Dec 1842
10
Polly Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.6]
b. 7 Nov 1773
John Robinson
b. Abt 1769
11
Tryphenia Robinson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.6.1]
b. Abt 1795
11
Lydia Robinson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.6.2]
b. Abt 1797
11
Ezekial Robinson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.6.3]
b. Abt 1799
11
Hiram Robinson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.6.4]
b. Abt 1801
11
Andrew Robinson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.6.5]
b. Abt 1803
11
John Robinson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.6.6]
b. Abt 1805
11
Norman Robinson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.6.7]
b. Abt 1807
10
Sally Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.7]
b. 13 Feb 1776 d. 24 Nov 1837
Amos Boyden
b. 1766 d. 30 Apr 1836
11
Abigail Boyden
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.7.1]
b. 6 Aug 1791
Allen Richardson
12
Sally Ann Richardson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.7.1.1]
b. 14 Jan 1816
12
Nancy L Richardson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.7.1.2]
b. 13 Apr 1818 d. 10 Jun 1895 [
=>
]
12
Isaac A Richardson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.7.1.3]
b. 26 Nov 1820
12
Susan Amy Richardson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.7.1.4]
b. 21 Feb 1823
12
Asenath T Richardson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.7.1.5]
b. 5 May 1825
12
Fanny J Richardson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.7.1.6]
b. 29 Nov 1827
12
Albert S Richardson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.7.1.7]
b. 18 Feb 1832 d. 8 Aug 1832
12
Allen Richardson
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.7.1.8]
d. 29 Apr 1835
11
Aseneth Boyden
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.7.2]
b. 10 Sep 1794 d. Apr 1886
+
Ellis Taft
b. 23 May 1796 d. 27 Aug 1851
11
David Boyden
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.7.3]
b. 11 Mar 1797
11
Nancy Boyden
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.7.4]
b. 23 Mar 1799
+
Salem Town
b. 1802
11
Sally Boyden
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.7.5]
b. 3 Apr 1806 d. 13 Sep 1808
11
William Collins Boyden
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.7.6]
b. 14 May 1801 d. 30 Nov 1803
11
Joel Boyden
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.7.7]
b. 7 Jul 1803 d. 2 Aug 1835
Mary Andrews
b. 1808 d. 12 Mar 1829
12
Amos Boyden
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.7.7.1]
b. 4 Aug 1827 [
=>
]
+
Rebecca Stearns
b. 1797 d. Apr 1833
11
Amy Smith Boyden
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.7.8]
b. 10 Jul 1808 d. 31 Jul 1838
11
William Collins Boyden
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.7.9]
b. 8 May 1811
Emily M Mowry
b. 13 Oct 1814 d. 25 May 1880
12
Mary Amanda Boyden
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.7.9.1]
b. 16 Aug 1834 [
=>
]
12
William Collins Boyden
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.7.9.2]
b. 3 Apr 1836 d. 20 Mar 1882
12
Sanford H Boyden
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.7.9.3]
b. 20 Dec 1838 d. 18 Sep 1869
12
Decatur M Boyden
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.7.9.4]
b. 21 Aug 1840 d. Abt 1951 [
=>
]
12
Emily Frances Boyden
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.7.9.5]
b. 19 Jan 1845 d. 17 Sep 1846
12
Emily Ann Boyden
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.7.9.6]
b. 10 Jan 1848 d. Abt 1958
12
Reuben M Boyden
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.7.9.7]
b. 19 Dec 1853 d. 5 Sep 1887
12
Amey Boyden
[1.1.3.3.1.1.2.5.1.7.9.8]
b. 23 May 1856 d. 30 Sep 1915
9
Henry Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.2]
b. 5 Dec 1743 d. 7 Dec 1777
Susanna Thayer
b. 23 Apr 1746 d. 4 Jan 1808
10
Hannah Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.2.1]
b. 7 May 1764
+
Aaron Legg
10
Joanna Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.2.2]
b. 6 Jul 1766 d. 29 Dec 1820
Daniel Holbrook
b. 7 Feb 1765 d. 10 Jun 1831
11
Henry Benson Holbrook
[1.1.3.3.1.1.2.5.2.2.1]
b. 21 Aug 1788 d. 1870
Rebecca Austin
b. 27 Oct 1796
12
Isaac Holbrook
[1.1.3.3.1.1.2.5.2.2.1.1]
b. 7 Nov 1816 d. 19 Apr 1875
12
Betsy Holbrook
[1.1.3.3.1.1.2.5.2.2.1.2]
b. 1821 d. 6 Dec 1897
12
Francis M Holbrook
[1.1.3.3.1.1.2.5.2.2.1.3]
b. 20 Jul 1823 d. 7 May 1906 [
=>
]
12
Charles Holbrook
[1.1.3.3.1.1.2.5.2.2.1.4]
b. 1834
11
Marcus Holbrook
[1.1.3.3.1.1.2.5.2.2.2]
b. Abt 1791 d. Aft 1840
+
Abigail Wild
11
Lydia Holbrook
[1.1.3.3.1.1.2.5.2.2.3]
b. Abt 1793 d. 19 Feb 1820
11
Daniel Holbrook
[1.1.3.3.1.1.2.5.2.2.4]
b. 28 Feb 1796 d. 18 Oct 1864
11
Rufus Holbrook
[1.1.3.3.1.1.2.5.2.2.5]
b. Abt 1801
Mary Wyman
b. 1801
12
Atward D Holbrook
[1.1.3.3.1.1.2.5.2.2.5.1]
b. 1831 d. 1900 [
=>
]
11
Abraham Staples Holbrook
[1.1.3.3.1.1.2.5.2.2.6]
b. Abt 1806 d. 1 May 1862
+
Sally Dearborn
b. 22 Jun 1807 d. 20 Mar 1863
11
Millins Holbrook
[1.1.3.3.1.1.2.5.2.2.7]
b. Abt 1808
Laura Temple
b. 5 May 1808 d. 12 Sep 1864
12
Harriet Elizabeth Holbrook
[1.1.3.3.1.1.2.5.2.2.7.1]
b. 14 Jan 1835 [
=>
]
12
Daniel Henry Holbrook
[1.1.3.3.1.1.2.5.2.2.7.2]
b. 9 Feb 1841
12
Fanny Maria Holbrook
[1.1.3.3.1.1.2.5.2.2.7.3]
b. 24 Dec 1841
12
George Benson Holbrook
[1.1.3.3.1.1.2.5.2.2.7.4]
b. Sep 1846 d. 4 Jul 1922 [
=>
]
10
Abigail Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.2.3]
b. 2 Jul 1768
+
Henry Staples
10
Henry Staples Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.2.4]
b. 8 Aug 1770 d. 29 Jul 1821
Lydia Sibley
b. 2 Apr 1769 d. 27 Nov 1822
11
Abigail Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.2.4.1]
b. 31 Mar 1795 d. 10 Nov 1821
Asa Legg
b. 7 May 1792 d. 15 Nov 1836
12
Charlotte Legg
[1.1.3.3.1.1.2.5.2.4.1.1]
b. 2 May 1818 d. 30 Oct 1900 [
=>
]
12
Lyman Legg
[1.1.3.3.1.1.2.5.2.4.1.2]
b. 3 Sep 1822 d. 1 Sep 1904 [
=>
]
11
Harriet Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.2.4.2]
b. 14 Sep 1796 d. 22 Aug 1852
11
Mellen Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.2.4.3]
b. 14 Jan 1798
Eliza W Farnum
b. 25 Sep 1802 d. 14 Sep 1839
12
Henry Staples Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.2.4.3.1]
b. 17 May 1829
12
Almira Farnum Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.2.4.3.2]
b. 6 Aug 1830 d. 25 Dec 1835
12
James Haskins Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.2.4.3.3]
b. 16 Oct 1833
12
George Everett Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.2.4.3.4]
b. 14 Aug 1837
+
Mary Windsor Peck
b. 21 May 1798
11
Hannah Adaline Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.2.4.4]
b. 12 Aug 1802 d. 19 Jun 1822
11
Rufus Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.2.4.5]
b. 24 Jan 1804 d. 23 Aug 1805
11
Chloe Ann Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.2.4.6]
b. 23 Aug 1806
+
Dan Hill
b. 29 Nov 1796
11
Susan Augusta Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.2.4.7]
b. 9 Oct 1809 d. 25 Jul 1831
Preserved Smith Thayer
b. 9 May 1808
12
Susan Benson Thayer
[1.1.3.3.1.1.2.5.2.4.7.1]
b. 28 Jun 1831 d. 14 Aug 1909
11
Rufus Aldrich Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.2.4.8]
b. 9 Oct 1809
+
Sarah E Buell
11
Stephen Sibley Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.2.4.9]
b. 9 Jan 1810 d. 20 Nov 1869
Elizabeth Richardson Scott
b. 8 Jan 1835 d. 20 Feb 1911
12
Jessie Harriet Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.2.4.9.1]
b. 7 Jun 1860
12
Fred Mellen Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.2.4.9.2]
b. 10 Nov 1862 d. 9 May 1864
12
Susie Adeline Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.2.4.9.3]
b. 6 Aug 1865
10
Tirza Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.2.5]
b. 29 Apr 1772
Wilder Johnson
b. 1768
11
Elmira Johnson
[1.1.3.3.1.1.2.5.2.5.1]
b. 1810 d. 27 May 1816
10
Susanna Thayer Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.2.6]
b. 19 Feb 1775
+
Gideon Angel
b. Abt 1770
10
Rachel Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.2.7]
b. 5 May 1777 d. 21 Nov 1842
General Charles Jenckes
b. 7 Aug 1767 d. 4 Jul 1838
11
Charles Benson Jenckes
[1.1.3.3.1.1.2.5.2.7.1]
b. 10 Apr 1796 d. Aft 1831
Hannah Ellis Thayer
b. 19 Mar 1800 d. 26 Feb 1818
12
Charles T Jenckes
[1.1.3.3.1.1.2.5.2.7.1.1]
b. 20 Feb 1818 d. 28 Feb 1818
Urana Thayer
b. 26 Dec 1801 d. 15 Nov 1822
12
Rufus A Jenckes
[1.1.3.3.1.1.2.5.2.7.1.2]
b. 22 Sep 1822 d. 11 Oct 1822
+
Alice T Thayer
b. Abt 1802 d. 28 Mar 1826
Ann Eliza Smith
b. 31 Dec 1805 d. 2 Apr 1865
12
Hannah Eliza Jenckes
[1.1.3.3.1.1.2.5.2.7.1.3]
b. 25 Nov 1827 d. 22 Oct 1890
12
Charles Henry Jenckes
[1.1.3.3.1.1.2.5.2.7.1.4]
b. 17 Nov 1829 d. 1862 [
=>
]
12
Ann Mariah Jenckes
[1.1.3.3.1.1.2.5.2.7.1.5]
b. 31 Dec 1831 d. 31 Jul 1910 [
=>
]
9
Joanna Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.3]
b. 14 Nov 1745 d. Bef 1806
9
Benoni Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.4]
b. 11 Jul 1747 d. 1803
Ruth Holbrook
b. 10 Aug 1751 d. 16 May 1781
10
Amasa Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.4.1]
b. 25 Jan 1771 d. 7 Mar 1837
Levina Turtilot
b. 20 Feb 1777 d. 1 May 1865
11
Henry Holbrook Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.4.1.1]
b. 22 Mar 1801
Almira A
b. 26 Aug 1817
12
Leander A Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.4.1.1.1]
b. 1838 d. 10 Aug 1839
12
Henry A Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.4.1.1.2]
b. 23 Feb 1843 d. 19 Aug 1844
12
Seth Hall Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.4.1.1.3]
b. 6 Jul 1847 d. 1915
12
Edwin Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.4.1.1.4]
b. Abt 1851
11
James Davis Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.4.1.2]
b. 15 Nov 1802 d. 5 Sep 1805
11
Chloe Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.4.1.3]
b. 2 Oct 1804 d. 28 Mar 1844
Horace B Robbins
b. 28 Mar 1797 d. 24 Feb 1879
12
Alvin Cook Robbins
[1.1.3.3.1.1.2.5.4.1.3.1]
b. 12 May 1828 [
=>
]
12
Ann Mariah Robbins
[1.1.3.3.1.1.2.5.4.1.3.2]
b. 6 Jul 1830
12
Henry Davis Robbins
[1.1.3.3.1.1.2.5.4.1.3.3]
b. 22 Sep 1834
12
Charles W Robbins
[1.1.3.3.1.1.2.5.4.1.3.4]
b. Abt 1837
12
Sanford Augustus Robbins
[1.1.3.3.1.1.2.5.4.1.3.5]
b. 9 May 1840
11
Maria R Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.4.1.4]
b. 17 Dec 1806
Alvin Cook
b. 1805 d. 9 Jun 1872
12
Ellen L Cook
[1.1.3.3.1.1.2.5.4.1.4.1]
b. 1830
12
Miriam A Cook
[1.1.3.3.1.1.2.5.4.1.4.2]
b. Oct 1834 d. 24 Mar 1835
12
Aaron Cook
[1.1.3.3.1.1.2.5.4.1.4.3]
b. 26 Jun 1837
12
Samantha Maria Cook
[1.1.3.3.1.1.2.5.4.1.4.4]
b. Abt 1841 [
=>
]
12
Alice Salina Cook
[1.1.3.3.1.1.2.5.4.1.4.5]
b. 26 Feb 1844
12
Winfield E Cook
[1.1.3.3.1.1.2.5.4.1.4.6]
b. 21 Jun 1847
12
Ellen Louisa Cooke
[1.1.3.3.1.1.2.5.4.1.4.7]
c. 3 Sep 1843
11
Charles Holbrook Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.4.1.5]
b. 14 Sep 1809
+
Adaline M Hayward
b. 22 Feb 1823
11
Angeline Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.4.1.6]
b. 20 Jul 1811
11
Ann Eliza Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.4.1.7]
b. 20 Feb 1813
11
Elsa T Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.4.1.8]
b. 17 Jul 1815
11
Nathan Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.4.1.9]
b. 30 Nov 1817
11
William Hall Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.4.1.10]
b. 24 Oct 1819
10
Chloe Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.4.2]
b. 28 Jan 1774
10
Benoni Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.4.3]
b. 1780 d. 1819
Ruth Sibley
b. 9 Apr 1745 d. 30 Nov 1814
10
John Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.4.4]
b. 1789
9
John Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5]
b. 1 Aug 1749 d. 18 May 1818
Mary Holbrook
b. 1 Feb 1762 d. 27 Dec 1814
10
John Perry Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.1]
b. 22 Jul 1781 d. 21 Jan 1842
Chloe Taft
b. 7 Jul 1785 d. 25 Apr 1826
11
Charlotte Taft Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.1.1]
b. 30 Sep 1807 d. 16 Jul 1878
Moses Dyer
b. 1803 d. Aft 1841
12
Merril B Dyer
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.1.1.1]
b. 2 Apr 1844 d. 2 Apr 1859
12
George Franklin Dyer
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.1.1.2]
b. 22 Jan 1846 d. 27 Feb 1917 [
=>
]
12
Chloe Allice Dyer
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.1.1.3]
b. 5 May 1848 d. 1932 [
=>
]
12
Angelne A Dyer
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.1.1.4]
b. 6 Sep 1852 [
=>
]
11
Ezra Taft Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.1.2]
b. 22 Feb 1811 d. 3 Sep 1869
Pamelia Andrus
b. 21 Oct 1809 d. 14 Sep 1877
12
Charles Agustus Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.1.2.1]
b. 26 Sep 1832 d. 14 Oct 1833
12
Chloe Jane Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.1.2.2]
b. 1835 d. 1835
12
Charles Augustus Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.1.2.3]
b. 9 Jul 1837 d. 18 Feb 1873
12
Jonathan Parsons Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.1.2.4]
b. Mar 1841 d. Mar 1841
12
Adin Parsons Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.1.2.5]
b. Mar 1841 d. Mar 1841
12
Pamelia Emma Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.1.2.6]
b. 28 Feb 1842 d. 10 Feb 1892
12
Harvey Andrus Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.1.2.7]
b. 26 Sep 1844 d. 26 Sep 1844
12
Isabella Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.1.2.8]
b. 9 Mar 1846 d. 10 Feb 1922
12
Charlotte Taft Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.1.2.9]
b. 4 Jul 1850 d. 30 Nov 1918 [
=>
]
Adeline Brooks Andrus
b. 18 Mar 1813 d. 20 Apr 1898
12
George Taft Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.1.2.10]
b. 1 May 1846 d. 16 May 1919 [
=>
]
12
Florence Adeline Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.1.2.11]
b. 17 Sep 1851 d. 25 Dec 1852
12
Nellie Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.1.2.12]
b. 30 Nov 1851 d. 24 Jan 1885
12
Frank Andrus Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.1.2.13]
b. 16 Oct 1853 d. 5 May 1937 [
=>
]
12
Samuel Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.1.2.14]
b. 1853
Eliza Ann Perry
b. 30 Mar 1828 d. 30 Apr 1913
12
Alice Eliza Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.1.2.15]
b. 11 Aug 1848 d. 3 Jun 1923
12
John Perry Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.1.2.16]
b. 24 Sep 1849 d. 4 Jan 1921
12
Malina Adelaide Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.1.2.17]
b. 21 Sep 1851 d. 31 Jul 1918
12
Orrin William Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.1.2.18]
b. 4 Oct 1853 d. 17 May 1917
12
Carrie Stella Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.1.2.19]
b. 22 May 1860 d. 15 Mar 1928
12
Abbie Della Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.1.2.20]
b. 16 Oct 1862 d. 22 Oct 1925
12
Grace Ann Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.1.2.21]
b. 31 Jan 1867 d. 15 Dec 1924
Elizabeth Gollaher
b. 30 Dec 1831 d. 4 May 1904
12
Fredrick Gollaher Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.1.2.22]
b. 17 Jan 1855 d. 6 Jan 1915
12
Brigham Young Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.1.2.23]
b. 17 Dec 1858 d. 11 Jul 1938
12
Luella Gollaher Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.1.2.24]
b. 12 Nov 1860 d. 22 Jul 1881
12
William C Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.1.2.25]
b. 11 Nov 1862 d. Sep 1937
12
Hyrum Smith Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.1.2.26]
b. 3 May 1864 d. 4 May 1935
12
Edith Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.1.2.27]
b. 22 Apr 1867 d. 11 Feb 1925
12
Lizzie Gollaher Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.1.2.28]
b. 9 Jul 1869 d. 30 Jul 1946
Olive Mary Knight
b. 24 Jan 1830 d. 27 Mar 1905
12
Louisa Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.1.2.29]
b. 29 Jun 1852 d. 29 Nov 1878
12
Heber Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.1.2.30]
b. Abt 1860 d. Bef 1868
12
Moroni Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.1.2.31]
b. 5 Nov 1861 d. 8 Jan 1934
12
Lorenzo Taft Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.1.2.32]
b. 3 Aug 1863 d. 6 Nov 1950
12
Joseph Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.1.2.33]
b. 13 Jul 1865 d. 5 Jun 1941
12
Ida May Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.1.2.34]
b. 16 Apr 1867 d. 30 Jun 1929
12
Don Carlos Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.1.2.35]
b. 29 Sep 1869 d. 19 Jan 1935
Mary Marie Larsen
b. 19 Dec 1843 d. 21 Feb 1926
12
Walter Taft Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.1.2.36]
b. 17 Jun 1867 d. 6 Jun 1957
12
Henry Taft Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.1.2.37]
b. 19 Mar 1869 d. 24 Feb 1947
+
Desdemona Wadsworth Fullmer
b. 6 Oct 1809 d. 9 Feb 1886
+
Lucinda Burton
b. 22 Oct 1825 d. 1 Oct 1863
11
George Taft Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.1.3]
b. Abt 1813
Prudence Maria Gifford
b. Abt 1815
12
Walter Everet Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.1.3.1]
b. 13 Sep 1857 d. 29 Apr 1907 [
=>
]
11
Hannah Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.1.4]
b. 18 Sep 1816
Henry Dodge
b. 15 Dec 1812 d. 22 Jun 1883
12
John M Dodge
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.1.4.1]
b. 1838 d. 14 Feb 1898
12
Abbie R Dodge
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.1.4.2]
b. 1850 d. 27 Sep 1916 [
=>
]
11
Abbie Ann Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.1.5]
b. Abt 1809 d. 21 Sep 1883
Calvin Rawson
b. 13 May 1797 d. 21 Jan 1868
12
Son Rawson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.1.5.1]
b. Abt 1828 d. Abt 1838
11
John M Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.1.6]
b. 1819 d. 12 Aug 1829
10
George Washington Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.2]
b. 25 May 1783 d. 10 Nov 1855
Alinda Warfield
b. 24 Aug 1785 d. 25 Apr 1841
11
Otis Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.2.1]
b. 28 Feb 1806 d. 16 Feb 1811
11
Harrison Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.2.2]
b. 10 Oct 1820 d. 25 Oct 1859
Marilla Adams
b. 12 Apr 1818 d. 16 Oct 1876
12
George Otis Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.2.2.1]
b. 24 Aug 1846 d. 2 May 1897
12
Reuben Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.2.2.2]
b. 1 Jan 1856 d. 25 Jul 1922
10
Jared Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.3]
b. 3 Feb 1785 d. 31 Jul 1854
Salley Taft
b. 21 Oct 1787 d. 7 Aug 1855
11
James Sulliven Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.3.1]
b. 19 Sep 1808 d. 3 Jan 1833
11
Putman Taft Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.3.2]
b. 28 Oct 1814 d. 24 Apr 1834
11
Jared Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.3.3]
b. 8 Nov 1821 d. 18 May 1894
Martha Taft
b. 23 Feb 1826 d. 19 Feb 1903
12
Sullivan Theodore Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.3.3.1]
b. 20 Apr 1844 d. 21 Sep 1911
12
Jared Irving Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.3.3.2]
b. 6 Oct 1846 d. 1919 [
=>
]
12
Walter Bryant Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.3.3.3]
b. 16 Jan 1850 d. 10 Feb 1860
12
Grace Sally Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.3.3.4]
b. 2 Sep 1852 d. 25 Feb 1863
11
Sylvanus Holbrook Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.3.4]
b. 23 Jun 1828 d. 1878
Laurett V Howard
b. 1830 d. 1860
12
Ellen Laura Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.3.4.1]
b. 18 Aug 1851 [
=>
]
12
Ernest S Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.3.4.2]
b. 25 May 1855
12
Laurett Victoria Howard Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.3.4.3]
b. 1859 d. 3 Jul 1883 [
=>
]
Lottie E. Kelly
12
Lottie E. Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.3.4.4]
b. 20 Sep 1866
10
Abigail Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.4]
b. 13 Feb 1787
Putman Taft
b. 5 Aug 1783 d. 20 Feb 1810
11
Mary Ann Taft
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.4.1]
b. 23 Oct 1807
+
Samuel T Holroyd
b. 1791 d. 4 Nov 1817
+
Angel Sweet
b. 7 Apr 1790 d. 28 Apr 1825
+
Edward Ide Bower
+
Joseph McDermott
10
Mary "Polly" Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.5]
b. 9 Jun 1788 d. 12 Jan 1864
Bailey Legg
b. 9 May 1783 d. 11 Oct 1862
11
Sylvanus B Legg
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.5.1]
b. 20 Jun 1813 d. Bef 8 Jun 1885
11
Mary H Legg
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.5.2]
b. 7 Jul 1815
11
Harriet H Legg
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.5.3]
b. 14 Jun 1817
10
Phyba Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.6]
b. Abt 1790
10
Prudence Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.7]
b. 7 Jul 1795
10
Thankful Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.8]
b. 26 Nov 1799 d. 1 May 1852
Joseph Bartlett Cook
b. 3 Dec 1796 d. 6 Oct 1856
11
William Walker Cook
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.8.1]
b. 21 Mar 1820
Nancy Marion Draper
b. 17 Mar 1823
12
Edwin L Cook
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.8.1.1]
b. 29 Mar 1857
11
Amanda Melvina Cook
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.8.2]
b. 12 Oct 1821
11
Mary Adeliza Cook
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.8.3]
b. 18 Apr 1824
11
Emily Caroline Cook
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.8.4]
b. 8 Feb 1826 d. 7 Mar 1826
11
Elma Ann Cook
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.8.5]
b. 29 Jan 1827 d. 13 Jan 1870
William Gibbs Comstock
b. 3 Feb 1827 d. 29 Apr 1914
12
Alice Ardella Comstock
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.8.5.1]
b. 10 Dec 1850 d. 20 Sep 1914 [
=>
]
12
Fanny Amanda Comstock
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.8.5.2]
b. 4 Jul 1854 d. 2 Sep 1934
10
Sulvanus Holbrook Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.9]
b. 12 Jan 1797 d. 24 Aug 1812
10
Judson Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.10]
b. Abt 1801 d. 15 Oct 1813
Joanna Taft
b. 14 Nov 1751 d. 3 Oct 1777
10
Lovett Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.11]
b. 6 Oct 1772 d. 4 Mar 1773
10
Lois Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.12]
b. 17 Jul 1774 d. 10 Jul 1840
Manassah Baker
b. 4 Oct 1765 d. 30 Jun 1831
11
Sarah Williams Baker
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.12.1]
b. 8 Feb 1796
Andre Taft
b. 25 Jun 1792 d. 26 Jun 1850
12
Margary Ann Taft
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.12.1.1]
b. 4 May 1818 d. 4 Nov 1904 [
=>
]
12
Caroline Taft
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.12.1.2]
b. 21 Aug 1821 d. 7 Nov 1907 [
=>
]
11
Sawyer Baker
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.12.2]
b. 5 Nov 1797 d. 14 Oct 1802
11
Mary Sawyer Baker
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.12.3]
b. 1 Apr 1800
11
Bezaleel Sawyer Baker
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.12.4]
b. 13 Sep 1802
11
William Henry Baker
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.12.5]
b. 8 Jun 1805
11
Chloe Taft Baker
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.12.6]
b. 17 Dec 1807
Faton Walker
12
Henry E Walker
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.12.6.1]
b. 15 Mar 1836
12
Harriet E Walker
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.12.6.2]
b. 15 Mar 1836 d. 30 Nov 1837
12
Edmund Walker
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.12.6.3]
b. 18 Dec 1837 d. 10 May 1844
12
Edgar Walker
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.12.6.4]
b. 18 Dec 1837 d. 24 Jan 1844
12
Adeline N Walker
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.12.6.5]
b. 7 Feb 1845 d. 1848
11
John William Baker
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.12.7]
b. 29 Sep 1810
11
Hannah Dike Baker
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.12.8]
b. 8 Nov 1813 d. 3 Jul 1836
11
John Brooks Baker
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.12.9]
b. 30 Jul 1816
11
Caleb Strong Baker
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.12.10]
b. 30 Jul 1816 d. 29 Dec 1834
10
Prudence Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.5.13]
b. 4 May 1776 d. 16 May 1789
9
Ichabod Benson
[1.1.3.3.1.1.2.5.6]
b. 4 May 1751 d. Bef 1806
8
Sarah White
[1.1.3.3.1.1.2.6]
b. 8 Nov 1724
8
Ebenezer White
[1.1.3.3.1.1.2.7]
b. 20 Nov 1726 d. 10 May 1812
Elizabeth Ellis
b. 10 Dec 1729
9
Ellis White
[1.1.3.3.1.1.2.7.1]
b. 13 Oct 1748
9
Turner White
[1.1.3.3.1.1.2.7.2]
b. Abt 1750 d. 6 Aug 1836
9
Abigail White
[1.1.3.3.1.1.2.7.3]
b. 9 Sep 1752
9
Smith White
[1.1.3.3.1.1.2.7.4]
b. 9 Oct 1755 d. 18 Apr 1823
9
Philadelphia White
[1.1.3.3.1.1.2.7.5]
b. 6 Oct 1760
9
Melatiah White
[1.1.3.3.1.1.2.7.6]
b. Abt 18 May 1766
9
Stephen White
[1.1.3.3.1.1.2.7.7]
b. 11 May 1761 d. 20 Oct 1860
8
Prudence White
[1.1.3.3.1.1.2.8]
b. 24 Sep 1729 d. Feb 1787
James Albee
b. 12 Mar 1721 d. 24 Nov 1795
9
Hope Albee
[1.1.3.3.1.1.2.8.1]
b. Abt 1765 d. 18 Jan 1840
Stephen Holbrook
b. 19 Jun 1764 d. 16 Aug 1830
10
Rachel Holbrook
[1.1.3.3.1.1.2.8.1.1]
b. 22 Apr 1789
10
Sylvanus Holbrook
[1.1.3.3.1.1.2.8.1.2]
b. 28 Jul 1792 d. 9 Dec 1855
10
Willard Holbrook
[1.1.3.3.1.1.2.8.1.3]
b. 7 Apr 1795 d. 4 Mar 1862
10
Wilder Holbrook
[1.1.3.3.1.1.2.8.1.4]
b. 7 Apr 1795 d. 2 Jan 1855
10
Chloe Holbrook
[1.1.3.3.1.1.2.8.1.5]
b. 13 Aug 1801 d. 11 Aug 1855
10
Henry Holbrook
[1.1.3.3.1.1.2.8.1.6]
b. 19 Apr 1804 d. 10 Jul 1874
10
Ellery Holbrook
[1.1.3.3.1.1.2.8.1.7]
b. 26 Jun 1810 d. 10 Jul 1847
9
Rachael Albee
[1.1.3.3.1.1.2.8.2]
b. Abt 1748 d. 1832
9
Lois Albee
[1.1.3.3.1.1.2.8.3]
b. 15 Feb 1759 d. 1841
9
Eunice Albee
[1.1.3.3.1.1.2.8.4]
b. 20 Apr 1763 d. 1845
9
James Albee
[1.1.3.3.1.1.2.8.5]
b. 11 Mar 1753 d. 18 Aug 1814
9
Abigail Albee
[1.1.3.3.1.1.2.8.6]
b. 1747 d. 1844
9
Alpheus Albee
[1.1.3.3.1.1.2.8.7]
b. 15 Feb 1761 d. 1847
9
Prudance Albe
[1.1.3.3.1.1.2.8.8]
b. 18 Jan 1770 d. 1795
9
Abiel Albee
[1.1.3.3.1.1.2.8.9]
b. 1756 d. 1827
8
Rachael White
[1.1.3.3.1.1.2.9]
b. 14 Nov 1732 d. 19 Mar 1808
Thomas Darling
b. 7 May 1730 d. 22 Oct 1776
9
Seth Darling
[1.1.3.3.1.1.2.9.1]
b. 21 Mar 1764 d. 27 Mar 1825
9
Nathan Darling
[1.1.3.3.1.1.2.9.2]
b. 17 Dec 1770 d. 7 Sep 1855
9
Simeon Darling
[1.1.3.3.1.1.2.9.3]
b. 21 Mar 1760 d. 4 Jun 1812
9
John Darling
[1.1.3.3.1.1.2.9.4]
b. 9 Jun 1768
9
Alpheus Darling
[1.1.3.3.1.1.2.9.5]
b. Abt 1770
9
Rhoda Darling
[1.1.3.3.1.1.2.9.6]
b. 8 May 1750 d. 25 Jan 1842
9
Joanna Darling
[1.1.3.3.1.1.2.9.7]
b. 1 Feb 1752
9
Rachel Darling
[1.1.3.3.1.1.2.9.8]
b. 1 May 1755 d. Bef 1818
Reuben Holbrook
b. 18 Jul 1754 d. 1835
10
Abigail Holbrook
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.1]
b. 8 Jan 1778
10
Rachael Holbrook
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.2]
b. 8 Jan 1780
Foster Verry
b. 7 Oct 1789 d. 1860
11
Albert Verry
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.2.1]
b. 15 Jul 1812
11
James Verry
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.2.2]
b. 27 Feb 1814
Nancy Nolen
12
Ester Jane Verry
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.2.2.1]
b. 19 Aug 1836 d. 10 Aug 1847
12
Isadore Verry
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.2.2.2]
b. 10 Jul 1839 [
=>
]
11
Chloe Holbrook Verry
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.2.3]
b. 20 Mar 1816
David Smith Wilder
b. 20 Aug 1813 d. 13 Nov 1898
12
Albert Verry Wilder
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.2.3.1]
b. 6 Feb 1838 d. Bef 1948
12
Foster Verry Wilder
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.2.3.2]
b. 16 Apr 1839 d. Bef 1949
12
Abel Wilder
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.2.3.3]
b. Abt 1840 d. Bef 1845
12
Chloeanna Wilder
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.2.3.4]
b. Abt 1842 d. Bef 1846
12
Clara Deetta Wilder
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.2.3.5]
b. Abt 1844 d. Bef 1850
12
Deetta Wilder
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.2.3.6]
b. Abt 1845 d. Bef 1851
11
Sally Verry
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.2.4]
b. 30 Apr 1818
11
Foster Verry
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.2.5]
b. 3 Oct 1821 d. 29 Jun 1837
10
Prudence Holbrook
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.3]
b. 25 Feb 1782
10
Anna Holbrook
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.4]
b. 30 Mar 1784 d. 16 Mar 1851
Samuel Fairbanks
b. 8 Apr 1784 d. 22 Jul 1845
11
Samuel Fairbanks
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.4.1]
b. Feb 1803 d. Aft 1852
11
Hester Fairbanks
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.4.2]
b. 11 Apr 1804 d. Bef 1825
11
Mary Ann Fairbanks
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.4.3]
b. 27 Apr 1806 d. 1858
Elhanim Hartwell
b. 1819
12
Eunice Elsie Hartwell
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.4.3.1]
b. 7 May 1849 [
=>
]
11
Elizabeth Fairbanks
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.4.4]
b. 14 Nov 1814 d. 12 Oct 1872
Stewart Smiley
b. Abt 1808 d. 1892
12
William G Smiley
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.4.4.1]
12
Thomas J Smiley
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.4.4.2]
12
Charels E Smiley
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.4.4.3]
12
Stuart Smiley
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.4.4.4]
12
Adelbert Smiley
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.4.4.5]
12
Frank B Smiley
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.4.4.6]
12
Abbie Smiley
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.4.4.7]
12
George Smiley
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.4.4.8]
12
Adelia Smiley
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.4.4.9]
12
Melvina Smiley
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.4.4.10]
12
Susan Smiley
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.4.4.11]
12
Mary Ann Smiley
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.4.4.12]
12
Fredrick Lee Smiley
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.4.4.13]
b. 23 Oct 1853 d. 17 Jun 1903 [
=>
]
11
Benjamin Fairbanks
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.4.5]
b. 17 Feb 1808 d. 7 Oct 1876
Eunice Mead
b. 14 Jan 1811 d. 20 Aug 1893
12
Frances Adelia Fairbanks
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.4.5.1]
b. 10 Mar 1832
12
Anna Fairbanks
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.4.5.2]
b. 7 Sep 1833
12
Esther Fairbanks
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.4.5.3]
b. 9 Mar 1835
12
Samuel Fairbanks
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.4.5.4]
b. 21 Mar 1837 d. 27 Sep 1881 [
=>
]
12
Alfred Fairbanks
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.4.5.5]
b. 2 Jun 1839 d. 6 May 1864
12
Sarah Melissa Fairbanks
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.4.5.6]
b. 9 Aug 1843 d. 1921 [
=>
]
12
Charles B Fairbanks
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.4.5.7]
b. 22 Sep 1846 [
=>
]
12
James Alonzo Fairbanks
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.4.5.8]
b. 14 Feb 1849 [
=>
]
11
Rachel Fairbanks
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.4.6]
b. 5 Jan 1810 d. Bef 1825
11
Reuben Fairbanks
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.4.7]
b. 2 Jun 1811 d. Bef 1825
11
Abbie Fairbanks
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.4.8]
b. Abt 1816
11
Charles Fairbanks
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.4.9]
b. 9 Mar 1817 d. 22 Oct 1869
Hanna Smith
b. Abt 1829
12
Delilah Fairbanks
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.4.9.1]
b. 1839
12
Esther Fairbanks
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.4.9.2]
b. 15 Dec 1841 d. 4 May 1912
12
Orlando Fairbanks
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.4.9.3]
b. 28 Dec 1842 d. 13 Feb 1871
12
Samuel Fairbanks
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.4.9.4]
b. 1844 d. 19 Feb 1923
12
Alice J Fairbanks
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.4.9.5]
b. 14 Apr 1847 d. 14 Feb 1897 [
=>
]
12
Benjamin Fairbanks
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.4.9.6]
b. 3 Dec 1848 d. 3 Feb 1925
12
Abbey D Fairbanks
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.4.9.7]
b. 4 Feb 1851 d. 4 Nov 1860
12
Sibyl Fairbanks
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.4.9.8]
b. 30 Jun 1852 d. 30 Aug 1852
12
Libbie Fairbanks
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.4.9.9]
b. 1856
12
Addie Fairbanks
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.4.9.10]
12
Lee Fairbanks
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.4.9.11]
11
Abigail C Fairbanks
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.4.10]
b. 11 Aug 1825 d. 30 Jun 1848
David R Garrison
b. 1824 d. 1898
12
Mary Garrison
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.4.10.1]
b. 1844 d. 1876
12
Cornelius Garrison
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.4.10.2]
b. Abt 1849 d. 1928
12
Annie Garrison
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.4.10.3]
b. 1853
12
Sarah Ellen Garrison
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.4.10.4]
b. 31 Mar 1856
12
Willie Garrison
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.4.10.5]
b. 1858
12
Bennie Garrison
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.4.10.6]
b. 1860
12
Frank L Garrison
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.4.10.7]
b. 25 May 1862
12
Georgianne Garrison
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.4.10.8]
b. 11 Oct 1869 [
=>
]
10
Benjamin Holbrook
[1.1.3.3.1.1.2.9.8.5]
b. 31 Jan 1786
9
Prudence Darling
[1.1.3.3.1.1.2.9.9]
b. 28 Sep 1757 d. 1827
9
Benjamin Darling
[1.1.3.3.1.1.2.9.10]
b. 28 Feb 1766 d. Bef 14 Apr 1776
7
Lydia White
[1.1.3.3.1.1.3]
b. 10 May 1686
7
Thomas White
[1.1.3.3.1.1.4]
b. 26 Nov 1688 d. 10 Nov 1746
7
Hannah White
[1.1.3.3.1.1.5]
b. 9 Dec 1691 d. Abt 1761
7
Mary White
[1.1.3.3.1.1.6]
b. 1692 d. 1707
7
Abigail White
[1.1.3.3.1.1.7]
b. 10 Nov 1693 d. Bef 22 Mar 1720
7
Rachel White
[1.1.3.3.1.1.8]
b. 27 Dec 1694
Joseph White
b. 1635 d. 23 Mar 1706
7
Lydia White
[1.1.3.3.1.1.9]
b. 17 Dec 1662 d. 2 Jan 1696
Samuel Cook
b. 21 Sep 1652 d. 1752
8
Experience Cook
[1.1.3.3.1.1.9.1]
b. 9 Nov 1662 d. 14 Jan 1707
8
Ebenezer Cook
[1.1.3.3.1.1.9.2]
b. 28 Oct 1682
8
Lydia Cook
[1.1.3.3.1.1.9.3]
b. 14 Mar 1686 d. 26 Feb 1743
8
Daniel Cook
[1.1.3.3.1.1.9.4]
b. 19 Sep 1691 d. 7 Feb 1737
8
Walter Cook
[1.1.3.3.1.1.9.5]
b. 1693 d. 2 Jan 1794
8
Hannah Cook
[1.1.3.3.1.1.9.6]
b. 29 Sep 1695 d. 2 Aug 1771
Joseph Taft
b. 26 May 1693 d. 20 Oct 1761
9
Aaron Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.1]
b. 26 Aug 1721 d. 4 Nov 1722
9
Joseph Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.2]
b. 15 Jan 1724 d. 1 Feb 1803
Elisabeth Cummings
d. 27 Aug 1770
10
Thomas Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.2.1]
b. 19 Aug 1754
10
Elisabeth Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.2.2]
b. 1 Jul 1756 d. 4 Sep 1797
10
Nathan Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.2.3]
b. 3 Jun 1758
10
Phebe Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.2.4]
b. 26 Nov 1760
+
Aaron Balkam
b. 1760 d. 1842
10
Eunice Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.2.5]
b. 11 Feb 1761 d. 1833
10
Hannah Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.2.6]
b. 1 Nov 1763 d. 3 Jul 1832
Eastman Taft
b. 16 Jun 1763 d. 29 Apr 1829
11
Chloe Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.2.6.1]
b. 7 Jul 1785 d. 25 Apr 1826
John Perry Benson
b. 22 Jul 1781 d. 21 Jan 1842
12
Charlotte Taft Benson
[1.1.3.3.1.1.9.6.2.6.1.1]
b. 30 Sep 1807 d. 16 Jul 1878 [
=>
]
12
Ezra Taft Benson
[1.1.3.3.1.1.9.6.2.6.1.2]
b. 22 Feb 1811 d. 3 Sep 1869 [
=>
]
12
George Taft Benson
[1.1.3.3.1.1.9.6.2.6.1.3]
b. Abt 1813 [
=>
]
12
Hannah Benson
[1.1.3.3.1.1.9.6.2.6.1.4]
b. 18 Sep 1816 [
=>
]
12
Abbie Ann Benson
[1.1.3.3.1.1.9.6.2.6.1.5]
b. Abt 1809 d. 21 Sep 1883 [
=>
]
12
John M Benson
[1.1.3.3.1.1.9.6.2.6.1.6]
b. 1819 d. 12 Aug 1829
11
Ezra Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.2.6.2]
b. 6 Mar 1793 d. 19 Feb 1808
10
Leonard Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.2.7]
b. 29 Mar 1767 d. 6 Feb 1846
Asenah Thayer
b. 7 Dec 1769 d. 22 Jul 1824
11
Willard Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.2.7.1]
b. 25 Aug 1791 d. 25 Feb 1832
Marietta Boyd
b. 1803
12
George Willard Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.2.7.1.1]
b. 27 Aug 1816 d. 1870
12
Susan Smith Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.2.7.1.2]
b. 3 Jun 1818 d. 1875
12
Asenath Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.2.7.1.3]
b. 21 Sep 1820 d. 18 May 1843 [
=>
]
12
Joseph Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.2.7.1.4]
b. 1828 d. 7 Oct 1831
12
Son Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.2.7.1.5]
b. 1831 d. 23 Jun 1832
11
Joseph Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.2.7.2]
b. 14 Oct 1793 d. 20 Dec 1869
Sophia Boyd
b. Abt 1800
12
Elmira D R Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.2.7.2.1]
b. 1821 [
=>
]
12
William A Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.2.7.2.2]
b. Abt 1836
11
Duty Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.2.7.3]
b. 30 Jun 1796 d. 22 Oct 1830
Judy Rounds
b. Abt 1797
12
David Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.2.7.3.1]
b. 13 Sep 1825 d. 26 Mar 1826
12
James Madison Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.2.7.3.2]
b. 27 Dec 1827 d. 21 Nov 1892
10
Cummings Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.2.8]
b. 27 Aug 1770 d. 22 Jun 1841
Marcy Green
b. 1 Jan 1760 d. 8 Jun 1815
11
Ezra Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.2.8.1]
b. 13 May 1797 d. 16 Nov 1878
Mercy G White
b. 1796 d. 14 Mar 1822
12
Austin Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.2.8.1.1]
b. 1 Mar 1822 d. 4 Sep 1844
Susanna Keith
b. 3 Jan 1801
12
Laura Ann M Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.2.8.1.2]
b. 26 Jun 1824 d. 26 May 1855 [
=>
]
12
Lucinda M Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.2.8.1.3]
b. 15 Mar 1826 d. 5 Mar 1906 [
=>
]
12
Artemas K Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.2.8.1.4]
b. 24 May 1828 d. 27 Dec 1878 [
=>
]
12
Uranah Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.2.8.1.5]
b. 25 Jan 1831
12
Daines C Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.2.8.1.6]
b. 1835 [
=>
]
12
Susan A Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.2.8.1.7]
b. 1838
12
Hannah Jane Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.2.8.1.8]
b. 17 Nov 1839 d. 7 Jan 1848
11
Benjamin Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.2.8.2]
b. 10 Aug 1798 d. 29 May 1799
11
Benjamin Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.2.8.3]
b. 6 May 1800 d. 17 Oct 1828
Martha Bethsheba White
b. 1803
12
Benjamin Lorin Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.2.8.3.1]
b. 25 Jun 1823
12
Russell White Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.2.8.3.2]
b. 23 Jan 1826 d. 4 Dec 1868
11
Hannah G Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.2.8.4]
b. 18 May 1802 d. 8 Jan 1843
Newell Taft
b. 28 Jul 1804 d. 4 Nov 1873
12
Albert Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.2.8.4.1]
b. 28 Aug 1823 d. Aft 1874 [
=>
]
12
Marcy Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.2.8.4.2]
b. Mar 1829 d. 12 Apr 1830
12
Charles M Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.2.8.4.3]
b. Jan 1843 d. 7 Dec 1843
9
Hannah Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.3]
b. 16 Nov 1725 d. 4 Nov 1822
Peter Keith
b. 23 Apr 1727 d. 1790
10
Joseph Keith
[1.1.3.3.1.1.9.6.3.1]
b. 20 Jul 1749
10
Debora Keith
[1.1.3.3.1.1.9.6.3.2]
b. 2 May 1751
10
Hannah Keith
[1.1.3.3.1.1.9.6.3.3]
b. 17 Jul 1753 d. 2 Apr 1842
Joseph Taft
b. 6 Jul 1751 d. 2 Jul 1828
11
Oliver Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.3.3.1]
b. 6 Nov 1771 d. 20 Feb 1853
Chloe
b. 1782 d. 24 Nov 1841
12
Olive Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.3.3.1.1]
b. 1 Mar 1806 d. 27 Jan 1867
12
Amariah Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.3.3.1.2]
b. 19 Sep 1807 d. 28 Aug 1873 [
=>
]
12
Oliver Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.3.3.1.3]
b. 16 Jun 1812 d. 25 Mar 1876 [
=>
]
12
Maryan Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.3.3.1.4]
b. 9 Jul 1814 [
=>
]
12
George Washington Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.3.3.1.5]
b. 13 May 1823
Laura Ann M Taft
b. 26 Jun 1824 d. 26 May 1855
12
Laura Ann Maria Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.3.3.1.6]
b. 7 Jul 1844
12
Son Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.3.3.1.7]
b. 7 Jul 1844 d. 21 Jul 1844
12
Joseph K Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.3.3.1.8]
b. 25 Sep 1846 d. Jul 1868
12
Chloe Jane Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.3.3.1.9]
b. 25 Nov 1849
11
Huldah Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.3.3.2]
b. 17 Feb 1775 d. Bef 21 May 1780
11
Huldah Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.3.3.3]
b. 21 May 1780 d. 11 Oct 1811
Parker Tyler
b. 14 Nov 1790 d. 28 Jun 1853
12
Huldah Tyler
[1.1.3.3.1.1.9.6.3.3.3.1]
b. 4 Oct 1811 [
=>
]
12
Hannah Tyler
[1.1.3.3.1.1.9.6.3.3.3.2]
b. 4 Oct 1811 d. 18 Oct 1811
12
Martha Almira Tyler
[1.1.3.3.1.1.9.6.3.3.3.3]
b. 28 Sep 1830 d. 16 Oct 1909 [
=>
]
11
Hannah Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.3.3.4]
b. 29 Sep 1783
11
Peter Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.3.3.5]
b. 24 Apr 1786
10
Mary Keith
[1.1.3.3.1.1.9.6.3.4]
b. 17 Sep 1755
10
Esther Keith
[1.1.3.3.1.1.9.6.3.5]
b. 23 Jan 1758 d. 4 Oct 1761
10
Peter Keith
[1.1.3.3.1.1.9.6.3.6]
b. 3 May 1760
+
Esther Alton
b. 23 Jun 1756
10
Barak Keith
[1.1.3.3.1.1.9.6.3.7]
b. 25 Aug 1762 d. 26 Mar 1833
10
Marshal Keith
[1.1.3.3.1.1.9.6.3.8]
b. 4 May 1765 d. 1817
10
Stephen Keith
[1.1.3.3.1.1.9.6.3.9]
b. 24 Aug 1768
9
Noah Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.4]
b. 1726 d. 2 Sep 1814
Margaret Keith
b. 1733 d. 1803
10
Deborah Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.1]
b. 30 Sep 1753
+
Samuel Penniman
b. 1 Dec 1748
10
Timothy Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.2]
b. 16 Feb 1755 d. 16 Nov 1827
Abigail Wright
b. 29 Nov 1754 d. 22 Nov 1840
11
Mary Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.2.1]
b. 20 Jan 1780 d. 15 Nov 1863
Peter Foster
b. 11 Feb 1779 d. 15 Aug 1829
12
Taft Foster
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.2.1.1]
b. 7 Mar 1801 d. 16 Feb 1852
12
Loring Foster
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.2.1.2]
b. 19 Feb 1803
12
Luther Foster
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.2.1.3]
b. 6 Jan 1805 d. 9 Oct 1857
12
Eliza Foster
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.2.1.4]
b. 21 Dec 1806
12
Adeline Foster
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.2.1.5]
b. 10 Dec 1808 d. 8 May 1884
12
Emily Foster
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.2.1.6]
b. 13 Jan 1811 d. 1884
12
Nancy Foster
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.2.1.7]
b. 16 Jun 1813
12
Albert Foster
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.2.1.8]
b. 8 Apr 1817 d. 23 Jun 1890
12
Mary E Foster
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.2.1.9]
b. 25 Sep 1822
12
Demarcus Foster
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.2.1.10]
b. 3 Apr 1825 d. 19 Oct 1876 [
=>
]
11
Sullivan Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.2.2]
b. 4 Sep 1781 d. 20 Mar 1865
Sally Flagg
b. 5 Mar 1783 d. 23 Aug 1870
12
Abigail Wright Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.2.2.1]
b. 25 Jul 1805 d. 22 Nov 1840 [
=>
]
12
Timothy Sullivan Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.2.2.2]
b. 21 Dec 1806
12
Mary Flagg Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.2.2.3]
b. 25 Oct 1808 d. 8 Aug 1900 [
=>
]
12
Lucy Eliza Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.2.2.4]
b. 8 Dec 1810 d. 10 Jun 1893 [
=>
]
12
Sarah Maria Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.2.2.5]
b. 25 Feb 1813 d. 23 Jul 1876 [
=>
]
12
Andrew Jackson Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.2.2.6]
b. 17 Apr 1815 d. 16 Feb 1817
12
Andrew Jackson Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.2.2.7]
b. 16 Feb 1817 d. 1909 [
=>
]
12
Adoniram Judson Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.2.2.8]
b. 15 Dec 1819
11
Adolphus Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.2.3]
b. 10 Jul 1784 d. 8 Feb 1857
Polly Johnson
b. 26 Nov 1783 d. 24 Nov 1864
12
Sarah Johnson Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.2.3.1]
b. 29 Nov 1809
12
Mary Adaline Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.2.3.2]
b. 27 Jun 1812 d. 25 Feb 1895 [
=>
]
12
William Harrison Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.2.3.3]
b. 8 Nov 1814 d. 27 Jun 1853
12
Betsy Eaton Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.2.3.4]
b. 14 Jan 1817
12
Rebecca Eaton Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.2.3.5]
b. 14 Mar 1819
12
Sylvia Holbrook Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.2.3.6]
b. 28 May 1821
12
George Washington Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.2.3.7]
b. 29 Aug 1823
11
David Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.2.4]
b. 1 Jan 1786
+
Azubah Elder
b. 1790
11
Joseph Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.2.5]
b. 26 Jun 1791 d. 15 May 1865
10
Emmeline Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.3]
b. Abt 1757
10
Noah Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.4]
b. 14 Jan 1758 d. 25 Feb 1828
Charlotte Arnold
b. 4 Sep 1771 d. 5 Feb 1848
11
Almira Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.4.1]
b. 9 Jun 1800 d. 1873
Collins Thayer
b. 7 Apr 1790 d. 19 Sep 1855
12
Adeline Thayer
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.4.1.1]
b. 1817
12
Virginia Thayer
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.4.1.2]
b. 1821
12
Elizabeth Thayer
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.4.1.3]
b. 1823
12
Collins Thayer
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.4.1.4]
b. 1825
12
Susan Thayer
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.4.1.5]
b. 27 Dec 1826 [
=>
]
12
Olive A Thayer
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.4.1.6]
b. Abt 1827
12
Mary Thayer
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.4.1.7]
b. 1828 [
=>
]
12
Almira Thayer
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.4.1.8]
b. 1831 d. 1895
11
Arnold Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.4.2]
b. 3 Feb 1793 d. 4 Feb 1865
Nancy Thayer
b. 1786 d. 1852
12
Mary Thayer
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.4.2.1]
b. 20 Sep 1820 d. 10 Oct 1888 [
=>
]
11
Noah Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.4.3]
b. 1795 d. 31 Oct 1869
11
Charlotte A Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.4.4]
b. 1796
11
Daniel O Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.4.5]
b. 1797 d. 11 May 1871
11
Susanna Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.4.6]
b. 1798 d. 1875
11
Mary A Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.4.7]
b. 1802 d. 23 May 1804
11
Olive Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.4.8]
b. 1804
10
Keith Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.5]
b. 1761 d. 10 Sep 1825
10
Chloa Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.6]
b. 25 Nov 1763 d. 4 May 1783
Eastman Taft
b. 16 Jun 1763 d. 29 Apr 1829
11
Eastman Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.6.1]
b. 2 May 1783 d. 8 Aug 1857
10
Micajah Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.7]
b. 8 Mar 1766 d. 9 Sep 1849
10
Charlotte Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.8]
b. 10 Jun 1768
10
David Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.9]
b. 1770 d. 5 May 1832
10
Gersham Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.10]
b. 1772
10
Joseph Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.11]
b. 1772 d. 23 Aug 1830
10
Charlotte Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.4.12]
b. 1774 d. 21 Jan 1777
9
Ezra Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.5]
b. 15 Apr 1731 d. 1761
9
Experience Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.6]
b. 7 Apr 1733 d. 15 Mar 1817
Elisha Taft
b. 3 May 1728 d. 3 Mar 1791
10
Hannah Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.6.1]
b. 16 Mar 1758
10
Elisha Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.6.2]
b. 4 Mar 1761 d. 16 Jan 1820
Mary Sadler
b. 15 Aug 1768 d. 1800
11
Hiram Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.6.2.1]
b. 2 Apr 1789 d. 15 Nov 1794
11
Elisha Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.6.2.2]
b. 23 Jul 1791 d. 26 Feb 1858
11
Ormon Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.6.2.3]
b. 11 Nov 1793 d. 23 Jan 1794
11
Mary Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.6.2.4]
b. 23 May 1795 d. 23 Feb 1875
10
Sarah Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.6.3]
b. 21 Mar 1763 d. 11 Oct 1835
Ezra Wood, Jr
b. 12 Mar 1759 d. 10 May 1837
11
Ezra Wood
[1.1.3.3.1.1.9.6.6.3.1]
b. 25 Oct 1781
11
Experience Wood
[1.1.3.3.1.1.9.6.6.3.2]
b. 16 Mar 1783 d. 14 Oct 1818
11
Sarah Wood
[1.1.3.3.1.1.9.6.6.3.3]
b. 7 Aug 1784
11
Elisha Wood
[1.1.3.3.1.1.9.6.6.3.4]
b. 24 Apr 1786 d. 19 Oct 1797
11
Jonathan Wood
[1.1.3.3.1.1.9.6.6.3.5]
b. 8 Oct 1787 d. 26 Feb 1846
11
Anna Wood
[1.1.3.3.1.1.9.6.6.3.6]
b. 31 Aug 1789 d. 20 Mar 1832
11
Chapin Wood
[1.1.3.3.1.1.9.6.6.3.7]
b. 2 Apr 1792
11
Lucy Wood
[1.1.3.3.1.1.9.6.6.3.8]
b. 11 Nov 1794 d. 10 Dec 1826
11
Silva Wood
[1.1.3.3.1.1.9.6.6.3.9]
b. 29 Apr 1796
11
Silva Wood
[1.1.3.3.1.1.9.6.6.3.10]
b. 29 Apr 1796
11
Phila Wood
[1.1.3.3.1.1.9.6.6.3.11]
b. 5 Jul 1798
11
Elisha Wood
[1.1.3.3.1.1.9.6.6.3.12]
b. 7 Nov 1800
11
Simeon Wood
[1.1.3.3.1.1.9.6.6.3.13]
b. 5 Jan 1805
10
Israel Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.6.4]
b. 12 Feb 1766
10
Joseph Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.6.5]
b. 15 Sep 1768 d. Aft 29 Sep 1815
Sarah Farrar
b. 14 Sep 1764 d. 5 Aug 1810
11
Experience
[1.1.3.3.1.1.9.6.6.5.1]
b. 5 Feb 1792
11
Amiel F Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.6.5.2]
b. 1 Oct 1794 d. 29 Nov 1869
11
Roxalana Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.6.5.3]
b. 22 Jan 1798
11
Sofrona Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.6.5.4]
b. 17 Jun 1800
11
Esquire Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.6.5.5]
b. 28 Apr 1803 d. 11 Mar 1865
11
Deborah R Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.6.5.6]
b. 6 Jan 1806
+
Marcy Stockwell
b. Abt 1794
9
Deborah Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.7]
b. 11 May 1735 d. 10 Dec 1738
9
Deborah Taft
[1.1.3.3.1.1.9.6.8]
b. 12 Mar 1744 d. 10 Dec 1778
8
Samuel Cook
[1.1.3.3.1.1.9.7]
b. 11 Jul 1698 d. Jan 1767
7
Thomas White
[1.1.3.3.1.1.10]
b. 1 Apr 1665 d. 18 Feb 1743
7
Samuel White
[1.1.3.3.1.1.11]
b. 14 Feb 1667 d. 18 Aug 1760
7
John White
[1.1.3.3.1.1.12]
b. 3 Dec 1668 d. 3 Apr 1725
7
Ebenezer White
[1.1.3.3.1.1.13]
b. 4 Dec 1670 d. 27 Aug 1726
7
Mary White
[1.1.3.3.1.1.14]
b. 12 Apr 1673 d. 24 Jan 1758
6
Thomas Copeland
[1.1.3.3.1.2]
b. 6 Feb 1654 d. 6 Jun 1706
6
Ephraim Copeland
[1.1.3.3.1.3]
b. 17 Nov 1655 d. 9 Aug 1690
6
William Copeland
[1.1.3.3.1.4]
b. 15 Nov 1656 d. 30 Oct 1716
6
John Copeland
[1.1.3.3.1.5]
b. 10 Feb 1659 d. 7 Aug 1714
6
Hannah Copeland
[1.1.3.3.1.6]
b. 25 Feb 1668 d. 10 Apr 1729
6
Richard Copeland
[1.1.3.3.1.7]
b. 15 Jul 1672 d. 15 Jul 1672
6
Abigail Copeland
[1.1.3.3.1.8]
b. Abt Oct 1673 d. 14 Feb 1752
5
Thomas Townsend
[1.1.3.3.2]
b. 1637 d. 1700
5
Samuel Townsend
[1.1.3.3.3]
b. 1638 d. 21 Dec 1704
5
John Townsend
[1.1.3.3.4]
b. Abt 1640 d. 4 Dec 1726
5
Andrew Townsend
[1.1.3.3.5]
b. 1642 d. 10 Feb 1692
5
Elizabeth Townsend
[1.1.3.3.6]
b. 1644 d. 19 Nov 1705
4
Grace Elizabeth Townsend
[1.1.3.4]
b. 22 Jun 1596 d. 2 Jan 1679
3
Bridget Townsend
[1.1.4]
b. Abt 1572
3
Alice Townsend
[1.1.5]
b. 22 May 1573
3
Elizabeth Townsend
[1.1.6]
b. 8 Apr 1577 d. 1637
2
Catherine Peryente
[1.2]
b. 1530 d. Oct 1577
William Clopton
b. 1500 d. 19 Aug 1562
3
George Clopton
[1.2.1]
b. Abt 1540 d. Abt 1587
3
Thomas Clopton
[1.2.2]
b. Abt 1543 d. 15 Feb 1597
3
Sir Thomas Clopton
[1.2.3]
b. Abt 1544 bur. 16 Feb 1597
3
Townsend Clopton
[1.2.4]
b. Abt 1545
3
Bridget Clopton
[1.2.5]
b. Abt 1558 d. 22 Jul 1625
Sir John Stafford
b. 1 Apr 1556 d. 28 Sep 1624
4
Humphrey Stafford
[1.2.5.1]
b. 1574 d. 1628
Lucie Ann Eyre
b. 1588 d. 1680
5
Alice Stafford
[1.2.5.1.1]
b. 1610 d. 1695
Captain Anthony Savage
c. 19 Jun 1623 d. 5 Jun 1695
6
Dorothy Savage
[1.2.5.1.1.1]
b. 1635 d. 1702
William Strother
b. 1630 d. 4 Nov 1702
7
Jeremiah Strother
[1.2.5.1.1.1.1]
b. 1655 d. 1741
7
James Strother
[1.2.5.1.1.1.2]
b. 1657 d. 1716
7
Benjamin Strother
[1.2.5.1.1.1.3]
b. Abt 1661 d. 5 May 1752
7
Mary Strother
[1.2.5.1.1.1.4]
b. 1664 d. 1752
7
William B Strother
[1.2.5.1.1.1.5]
b. 1 Nov 1653 d. 26 Jul 1726
Margaret Thornton
b. 2 Apr 1678 d. 1 Aug 1727
8
Francis Thorton Strother
[1.2.5.1.1.1.5.1]
b. 1700 d. 1752
8
John Strother
[1.2.5.1.1.1.5.2]
b. 1704
8
Margaret Strother
[1.2.5.1.1.1.5.3]
b. 1 Aug 1704 d. 1776
8
Benjamin Strother
[1.2.5.1.1.1.5.4]
b. 1706 d. 1789
8
Mary Strother
[1.2.5.1.1.1.5.5]
b. 1708
8
George Strother
[1.2.5.1.1.1.5.6]
b. Abt 1710 d. Aft 7 Apr 1726
8
Alice Strother
[1.2.5.1.1.1.5.7]
b. 1710 d. 1792
8
Anthony Strother
[1.2.5.1.1.1.5.8]
b. 1 Aug 1710 d. 10 Dec 1765
8
Anne Strother
[1.2.5.1.1.1.5.9]
b. Abt 1712
8
Alice Strother
[1.2.5.1.1.1.5.10]
b. 1723
8
William Dabney Strother
[1.2.5.1.1.1.5.11]
b. 30 Apr 1726 d. 5 Nov 1808
Sarah Bailey
b. 28 Jan 1720 d. 22 Dec 1774
9
William Dabney Strother, Jr.
[1.2.5.1.1.1.5.11.1]
b. 1751 d. 15 Mar 1781
9
Susannah Dabney Strother
[1.2.5.1.1.1.5.11.2]
b. 1754 d. 1822
9
Sarah Dabney Strother
[1.2.5.1.1.1.5.11.3]
b. 11 Dec 1760 d. 13 Dec 1822
Richard Lee Taylor
b. 3 Apr 1744 d. 19 Jan 1829
10
Strother Taylor
[1.2.5.1.1.1.5.11.3.1]
b. Abt 1780
10
Mary Taylor
[1.2.5.1.1.1.5.11.3.2]
b. 1781 d. 1880
10
Hancock Taylor
[1.2.5.1.1.1.5.11.3.3]
b. 29 Jan 1781 d. 29 Mar 1841
10
Elizabeth Taylor
[1.2.5.1.1.1.5.11.3.4]
b. 1783 d. 1835
10
President Zachery Taylor
[1.2.5.1.1.1.5.11.3.5]
b. 24 Nov 1784 d. 9 Jul 1850
Margaret Mackall "Peggy" Smith
b. 21 Sep 1788 d. 14 Aug 1852
11
Anna Mackall Taylor
[1.2.5.1.1.1.5.11.3.5.1]
b. 1811 d. 1875
11
Sara Knox "Knoxie" Taylor
[1.2.5.1.1.1.5.11.3.5.2]
b. 6 Mar 1814 d. 15 Sep 1835
+
Jefferson Finis Davis
b. 3 Jun 1808 d. 6 Dec 1889
11
Mary Elizabeth "Betty" Taylor
[1.2.5.1.1.1.5.11.3.5.3]
b. 1824 d. 1909
11
Richard Scott "Dick" Taylor
[1.2.5.1.1.1.5.11.3.5.4]
b. 27 Jan 1826 d. 12 Apr 1879
10
Joseph Pannell Taylor
[1.2.5.1.1.1.5.11.3.6]
b. 4 May 1796 d. 29 Jun 1864
10
Emily Richard Taylor
[1.2.5.1.1.1.5.11.3.7]
b. 30 Jun 1801 d. 1841
10
William Taylor
[1.2.5.1.1.1.5.11.3.8]
b. 8 Jul 1806 d. 9 Mar 1891
10
James Taylor
[1.2.5.1.1.1.5.11.3.9]
6
John Savage
[1.2.5.1.1.2]
b. 1637 d. 11 Aug 1701
6
Anthony Savage
[1.2.5.1.1.3]
b. 1640 d. 5 Jun 1695
6
Thomas Savage
[1.2.5.1.1.4]
b. Abt 1643 bur. 11 Dec 1700
6
Francis Savage
[1.2.5.1.1.5]
b. 1644
6
Alice Stafford Savage
[1.2.5.1.1.6]
b. 1 Aug 1653 d. 5 Jun 1695
Francis Thornton
b. 5 Nov 1651 d. 7 Oct 1726
7
Elizabeth Thornton
[1.2.5.1.1.6.1]
b. 3 Jan 1674 d. Dec 1732
Colonel Edwin Conway
b. 1653 d. 7 Sep 1698
8
Francis Conway
[1.2.5.1.1.6.1.1]
b. 15 Apr 1696 d. 12 Apr 1733
Rebecca Catlett
b. 27 Dec 1702 d. 6 Mar 1760
9
Catlett Conway
[1.2.5.1.1.6.1.1.1]
b. 11 Jan 1719
9
George Conway
[1.2.5.1.1.6.1.1.2]
b. 1720 d. 1754
9
Francis Conway
[1.2.5.1.1.6.1.1.3]
b. 27 Dec 1722 d. 17 May 1761
9
Reuben Conway
[1.2.5.1.1.6.1.1.4]
b. Nov 1725
9
Sarah Conway
[1.2.5.1.1.6.1.1.5]
b. 27 Aug 1727 d. 1800
9
Jane Conway
[1.2.5.1.1.6.1.1.6]
b. 22 Dec 1729
9
Eleanor Rose Conway
[1.2.5.1.1.6.1.1.7]
b. 9 Jan 1731 d. 11 Feb 1829
Colonel James Madison
b. 27 Mar 1723 d. 27 Feb 1801
10
President James Madison, Jr
[1.2.5.1.1.6.1.1.7.1]
b. 16 Mar 1751 d. 28 Jun 1836
+
Dolley Payne
b. 20 May 1768 d. 12 Jul 1849
10
Francis Taylor Madison
[1.2.5.1.1.6.1.1.7.2]
b. 18 Jun 1753 d. 5 Apr 1800
10
Major Ambrose Madison
[1.2.5.1.1.6.1.1.7.3]
b. 22 Jan 1755 d. 3 Oct 1793
10
Catlett Madison
[1.2.5.1.1.6.1.1.7.4]
b. 10 Feb 1758 d. 18 Mar 1758
10
Eleanor Conway Madison
[1.2.5.1.1.6.1.1.7.5]
b. 14 Feb 1760 d. 24 Dec 1802
10
General William Taylor Madison
[1.2.5.1.1.6.1.1.7.6]
b. 5 May 1762 d. 20 Jul 1843
10
Sarah Catlett Madison
[1.2.5.1.1.6.1.1.7.7]
b. 17 Aug 1764 d. 17 Oct 1843
10
Son Madison
[1.2.5.1.1.6.1.1.7.8]
b. 12 Jan 1766 d. 13 Jan 1766
10
Elizabeth Madison
[1.2.5.1.1.6.1.1.7.9]
b. 6 Feb 1768 d. 17 May 1775
10
Son Madison
[1.2.5.1.1.6.1.1.7.10]
b. 12 Jul 1770 d. 12 Jul 1770
10
Reuben Madison
[1.2.5.1.1.6.1.1.7.11]
b. 19 Sep 1771 d. 17 May 1775
10
Frances Taylor Madison
[1.2.5.1.1.6.1.1.7.12]
b. 4 Oct 1774 d. 4 Oct 1823
8
Sarah Conway
[1.2.5.1.1.6.1.2]
b. Abt 1698 d. 1775
8
Son Conway
[1.2.5.1.1.6.1.3]
b. Abt 1698
7
Margaret Thornton
[1.2.5.1.1.6.2]
b. 2 Apr 1678 d. 1 Aug 1727
William B Strother
b. 1 Nov 1653 d. 26 Jul 1726
8
Francis Thorton Strother
[1.2.5.1.1.6.2.1]
b. 1700 d. 1752
8
John Strother
[1.2.5.1.1.6.2.2]
b. 1704
8
Margaret Strother
[1.2.5.1.1.6.2.3]
b. 1 Aug 1704 d. 1776
8
Benjamin Strother
[1.2.5.1.1.6.2.4]
b. 1706 d. 1789
8
Mary Strother
[1.2.5.1.1.6.2.5]
b. 1708
8
George Strother
[1.2.5.1.1.6.2.6]
b. Abt 1710 d. Aft 7 Apr 1726
8
Alice Strother
[1.2.5.1.1.6.2.7]
b. 1710 d. 1792
8
Anthony Strother
[1.2.5.1.1.6.2.8]
b. 1 Aug 1710 d. 10 Dec 1765
8
Anne Strother
[1.2.5.1.1.6.2.9]
b. Abt 1712
8
Alice Strother
[1.2.5.1.1.6.2.10]
b. 1723
8
William Dabney Strother
[1.2.5.1.1.6.2.11]
b. 30 Apr 1726 d. 5 Nov 1808
Sarah Bailey
b. 28 Jan 1720 d. 22 Dec 1774
9
William Dabney Strother, Jr.
[1.2.5.1.1.6.2.11.1]
b. 1751 d. 15 Mar 1781
9
Susannah Dabney Strother
[1.2.5.1.1.6.2.11.2]
b. 1754 d. 1822
9
Sarah Dabney Strother
[1.2.5.1.1.6.2.11.3]
b. 11 Dec 1760 d. 13 Dec 1822
Richard Lee Taylor
b. 3 Apr 1744 d. 19 Jan 1829
10
Strother Taylor
[1.2.5.1.1.6.2.11.3.1]
b. Abt 1780
10
Mary Taylor
[1.2.5.1.1.6.2.11.3.2]
b. 1781 d. 1880
10
Hancock Taylor
[1.2.5.1.1.6.2.11.3.3]
b. 29 Jan 1781 d. 29 Mar 1841
10
Elizabeth Taylor
[1.2.5.1.1.6.2.11.3.4]
b. 1783 d. 1835
10
President Zachery Taylor
[1.2.5.1.1.6.2.11.3.5]
b. 24 Nov 1784 d. 9 Jul 1850
Margaret Mackall "Peggy" Smith
b. 21 Sep 1788 d. 14 Aug 1852
11
Anna Mackall Taylor
[1.2.5.1.1.6.2.11.3.5.1]
b. 1811 d. 1875
11
Sara Knox "Knoxie" Taylor
[1.2.5.1.1.6.2.11.3.5.2]
b. 6 Mar 1814 d. 15 Sep 1835
+
Jefferson Finis Davis
b. 3 Jun 1808 d. 6 Dec 1889
11
Mary Elizabeth "Betty" Taylor
[1.2.5.1.1.6.2.11.3.5.3]
b. 1824 d. 1909
11
Richard Scott "Dick" Taylor
[1.2.5.1.1.6.2.11.3.5.4]
b. 27 Jan 1826 d. 12 Apr 1879
10
Joseph Pannell Taylor
[1.2.5.1.1.6.2.11.3.6]
b. 4 May 1796 d. 29 Jun 1864
10
Emily Richard Taylor
[1.2.5.1.1.6.2.11.3.7]
b. 30 Jun 1801 d. 1841
10
William Taylor
[1.2.5.1.1.6.2.11.3.8]
b. 8 Jul 1806 d. 9 Mar 1891
10
James Taylor
[1.2.5.1.1.6.2.11.3.9]
7
William Thornton
[1.2.5.1.1.6.3]
b. 17 Dec 1680 d. Abt 1743
7
Sarah Alice Thornton
[1.2.5.1.1.6.4]
b. 17 Dec 1680 d. 1757
7
Francis Thornton
[1.2.5.1.1.6.5]
b. 4 Jan 1682 d. 6 Feb 1737
7
Rowland Thornton
[1.2.5.1.1.6.6]
b. 1 Aug 1685 d. 1748
7
Anne Thornton
[1.2.5.1.1.6.7]
b. 22 Mar 1689 d. May 1726
7
Anthony Thornton
[1.2.5.1.1.6.8]
b. 27 Sep 1691 d. 8 Nov 1757
4
Jane Stafford
[1.2.5.2]
b. 1581 d. 1637
2
Dorothy Peryente
[1.3]
b. Abt 1540