Home Page
|
What's New
|
Photos
|
Histories
|
Headstones
|
Reports
|
Surnames
Search
First Name:
Last Name:
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Suomalainen
Svenska
Mawde Hiscoxe
1562 - 1645 (~ 82 years)
Submit Photo / Document
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Submit Photo / Doc
Worksheet
Family
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Mawde Hiscoxe
[1]
c. 20 Sep 1562 d. 1645
William Jones
b. 1579 d. 16 Oct 1660
2
Elizabeth Jones
[1.1]
c. 15 Sep 1602
2
Lewis J Jones
[1.2]
b. 6 Apr 1605 d. 11 Apr 1684
Anne Cooper
b. 1602 d. 1 May 1680
3
Lewis Jones
[1.2.1]
b. 1635 d. 20 Jun 1696
Deborah Palmer
b. 5 Feb 1642 d. Oct 1727
4
Hannah Jones
[1.2.1.1]
b. 1662
Stephen DeWolf
b. May 1650 d. 17 Oct 1702
5
Deborah DeWolf
[1.2.1.1.1]
b. 25 Jul 1690 d. 26 Sep 1748
Aaron Huntley, Jr
b. 11 Dec 1680 d. 26 Sep 1748
6
Hannah Huntley
[1.2.1.1.1.1]
b. 22 Jul 1708 d. 1796
Ebenezar Mack
b. 8 Dec 1697 d. 8 May 1777
7
Phebe Mack
[1.2.1.1.1.1.1]
b. 20 Jan 1729 d. 1816
7
Deborah Mack
[1.2.1.1.1.1.2]
b. 15 Sep 1730
7
Solomon Mack
[1.2.1.1.1.1.3]
b. 15 Sep 1732 d. 23 Aug 1820
Lydia Gates
b. 3 Sep 1732 d. 9 Mar 1817
8
Lovina Mack
[1.2.1.1.1.1.3.1]
b. 1762 d. 1789
8
Lydia Mack
[1.2.1.1.1.1.3.2]
b. 1764 d. 8 Jan 1826
8
Colonel Stephen Mack
[1.2.1.1.1.1.3.3]
b. 15 Jun 1766 d. 11 Nov 1826
8
Minister Jason Mack
[1.2.1.1.1.1.3.4]
b. 15 Jun 1766 d. 1835
8
Daniel Gates Mack
[1.2.1.1.1.1.3.5]
b. 1770 d. 28 Oct 1851
8
Captain Soloman Mack, Jr
[1.2.1.1.1.1.3.6]
b. 28 Jan 1773 d. 28 Oct 1851
8
Lucy Mack
[1.2.1.1.1.1.3.7]
b. 8 Jul 1775 d. 14 May 1856
Joseph Smith
b. 12 Jul 1771 d. 14 Sep 1840
9
Son Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.1]
b. 1797 d. 1797
9
Daughter Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.2]
b. 1797 d. 1797
9
Alvin Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.3]
b. 11 Feb 1798 d. 19 Nov 1823
9
Hyrum Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4]
b. 9 Feb 1800 d. 27 Jun 1844
Jerusha Barden
b. 15 Feb 1805 d. 13 Oct 1837
10
Lovina Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.1]
b. 16 Sep 1827 d. 8 Oct 1876
10
Mary Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.2]
b. 27 Jun 1829 d. 29 May 1832
10
John Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.3]
b. 22 Sep 1832
10
Hyrum Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.4]
b. 27 Apr 1834 d. 21 Sep 1841
10
Jerusha Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.5]
b. 13 Jan 1836 d. 27 Jun 1912
10
Sarah Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.6]
b. 2 Oct 1837 d. 6 Nov 1876
Mary Fielding
b. 21 Jul 1801 d. 21 Sep 1852
10
Joseph Fielding Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7]
b. 13 Nov 1838 d. 19 Nov 1918
+
Levira Annette Clark Smith
b. 29 Apr 1842 d. 18 Dec 1888
Julina Lambson
b. 18 Jun 1849 d. 10 Jan 1936
11
Edward Aurthur Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.1]
b. 1 Nov 1858 d. 17 Jul 1911
11
Mercy Josephine Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.2]
b. 14 Aug 1867 d. 6 Jun 1870
11
Mary Sophronia Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.3]
b. 7 Oct 1869 d. 5 Jan 1948
11
Donnette Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.4]
b. 17 Sep 1872 d. 16 Sep 1961
11
Joseph Fielding Smith, Jr
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.5]
b. 19 Jul 1876 d. 2 Jul 1972
Emily Louie Shurtliff
b. 16 Jun 1876 d. 30 Mar 1908
12
Josephine Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.5.1]
b. 18 Sep 1902 d. 16 Sep 1995
12
Julina Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.5.2]
b. 5 Feb 1906 d. 9 May 1997
Ethel Georgina Reynolds
b. 23 Oct 1889 d. 26 Aug 1937
12
Emily Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.5.3]
b. 9 Aug 1909 d. 21 Aug 1994
12
Naomi Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.5.4]
b. 16 Nov 1910 d. 15 Oct 1979
12
Lois Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.5.5]
b. 26 Mar 1912 d. 23 Jan 1981
12
Joseph Fielding Smith, Jr
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.5.6]
b. 18 Dec 1913 d. 23 Aug 1974
12
Amelia Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.5.7]
b. 21 Jun 1916 d. 22 Sep 2005 [
=>
]
12
Lewis Warren Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.5.8]
b. 10 Mar 1918 d. 12 Dec 1944
12
George Reynolds Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.5.9]
b. 13 Feb 1921 d. 28 Oct 1982
12
Living
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.5.10]
12
Living
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.5.11]
+
Jessie Ella Evans
b. 29 Dec 1902 d. 3 Aug 1971
11
David Asael Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.6]
b. 24 May 1879 bur. 9 Apr 1952
11
George Carlos Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.7]
b. 14 Oct 1881 d. 25 Feb 1931
11
Julina Clarissa Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.8]
b. 10 Feb 1884 d. 1 Aug 1923
11
Elias Wesley Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.9]
b. 21 Apr 1886 d. 28 Dec 1970
11
Emily Jane Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.10]
b. 11 Sep 1888 d. 12 Dec 1982
11
Rachel Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.11]
b. 11 Dec 1890 d. 14 Dec 1986
11
Edith Eleanor Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.12]
b. 3 Jan 1894 d. 21 May 1987
11
Marjorie Virginia Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.13]
b. 7 Dec 1906 d. 17 Nov 1994
Sarah Ellen Richards
b. 25 Aug 1850 d. 22 Mar 1915
11
Sarah Ellen Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.14]
b. 5 Feb 1869 d. 11 Feb 1869
11
Leonora Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.15]
b. 30 Jan 1871 bur. 26 Dec 1907
11
Joseph Richards Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.16]
b. 22 Feb 1873 d. 2 Oct 1954
11
Heber John Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.17]
b. 3 Jul 1876 d. 3 Mar 1877
11
Rhoda Ann Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.18]
b. 20 Jul 1878 d. 6 Jul 1879
11
Minerva Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.19]
b. 30 Apr 1880 d. 24 Jan 1958
11
Alice Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.20]
b. 27 Jul 1882 d. 29 Apr 1901
11
Willard Richards Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.21]
b. 20 Nov 1884 d. 11 Sep 1972
Florence Grant
b. 7 Feb 1883 d. 6 Mar 1977
12
Willard Grant Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.21.1]
b. 12 May 1911 d. 16 Dec 1996
12
Florence Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.21.2]
b. 7 Apr 1913 d. 5 Mar 2017
12
Richards Grant Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.21.3]
b. 10 Mar 1915 d. 6 Mar 2000
12
Briant Grant Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.21.4]
b. 15 Dec 1916 d. 6 Jan 2006
12
Heber Joseph Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.21.5]
b. 23 Dec 1918 d. 26 Nov 1943
12
Howard Grant Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.21.6]
b. 13 Mar 1921 d. 28 May 2010
12
Sarah Ellen Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.21.7]
b. 5 May 1923 d. 23 Oct 1980 [
=>
]
12
Paul Grant Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.21.8]
b. 19 May 1925 d. 21 Jan 2000
11
Franklin Richards Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.22]
b. 12 May 1888 d. 25 Dec 1967
11
Jeanetta Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.23]
b. 25 Aug 1891 d. 27 Jan 1932
11
Asenath Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.24]
b. 28 Dec 1896 d. 3 Aug 1982
Edna Lambson
b. 3 Mar 1851
11
Hyrum Mack Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.25]
b. 21 Mar 1872 d. 23 Jan 1918
11
Alvin Fielding Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.26]
b. 7 Aug 1874 d. 4 Jan 1948
11
Alfred Jason Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.27]
b. 13 Dec 1876 d. 6 Apr 1878
11
Edna Melissa Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.28]
b. 6 Oct 1879 d. 26 Oct 1958
11
Albert Jesse Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.29]
b. 16 Sep 1881 d. 25 Aug 1883
11
Robert Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.30]
b. 12 Nov 1883 d. 4 Feb 1886
11
Emma Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.31]
b. 21 Aug 1888 d. 29 Dec 1969
11
Zina Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.32]
b. 11 Oct 1890 d. 25 Oct 1915
11
Ruth Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.33]
b. 21 Dec 1893 d. 17 Mar 1898
11
Martha Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.34]
b. 12 May 1897 d. 7 Aug 1977
Alice Ann Kimball
b. 6 Sep 1858 d. 19 Dec 1946
11
Alice May Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.35]
b. 11 Oct 1877 d. 20 Oct 1920
11
Heber Chase Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.36]
b. 19 Nov 1881 d. 29 Dec 1971
11
Charles Coulson Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.37]
b. 19 Nov 1881 d. 21 Apr 1933
11
Lucy Mack Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.38]
b. 14 Apr 1890 d. 24 Nov 1933
11
Andrew Kimball Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.39]
b. 6 Jan 1893 d. 23 Aug 1951
11
Jesse Kimball Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.40]
b. 21 May 1896 d. 21 May 1953
11
Fielding Kimball Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.41]
b. 9 Apr 1900 d. 20 Oct 1974
Mary Taylor Schwartz
b. 30 Apr 1865 d. 5 Dec 1956
11
John Schwartz Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.42]
b. 20 Aug 1888 d. 3 Aug 1889
11
Calvin Schwartz Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.43]
b. 29 May 1890
11
Samuel Schwartz Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.44]
b. 26 Oct 1892 d. 10 May 1983
11
James Schwartz Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.45]
b. 13 Nov 1894 d. 6 Nov 1950
11
Agnes Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.46]
b. 3 Nov 1897 d. 9 Mar 1966
11
Silas Schwartz Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.47]
b. 3 Jan 1900 d. 23 Apr 1983
11
Royal Grant Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.7.48]
b. 21 May 1906 d. 30 May 1971
10
Martha Ann Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.8]
b. 14 May 1841 d. 19 Oct 1923
William Jasper Harris
b. 25 Oct 1836 d. 24 Apr 1909
11
William Jasper Harris, Jr
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.8.1]
b. 4 Aug 1859 d. 23 Aug 1926
11
Joseph Albert Harris
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.8.2]
b. 19 Aug 1861 d. 28 May 1911
11
Hyrum Smith Harris
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.8.3]
b. 15 Aug 1863 d. 24 Feb 1924
11
Mary Emily Harris
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.8.4]
b. 23 Oct 1865 d. 25 Nov 1947
11
Franklin Hill Harris
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.8.5]
b. 11 Sep 1867 d. 5 Feb 1947
11
Lucy Smith Harris
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.8.6]
b. 10 Mar 1870 d. 25 Jul 1903
11
John Fielding Harris
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.8.7]
b. 28 Jun 1872 d. 28 Nov 1946
11
Mercy Ann Harris
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.8.8]
b. 30 Mar 1874 d. 23 Jan 1905
11
Zina Christine Harris
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.8.9]
b. 13 May 1876 d. 16 Mar 1958
11
Martha Artemesia Harris
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.8.10]
b. 27 Jun 1879 d. 12 Aug 1965
11
Sarah Lovina Harris
[1.2.1.1.1.1.3.7.4.8.11]
b. 8 Dec 1882 d. 21 Apr 1961
+
Catherine Phillips
b. 1 Aug 1819 d. 26 Sep 1905
+
Mercy Rachel Fielding
b. 15 Jun 1807 d. 15 Sep 1893
9
Sophronia Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.5]
b. 17 May 1803 d. 28 Oct 1876
Calvin W Stoddard
b. 7 Sep 1801 d. 19 Nov 1836
10
Eunice Stoddard
[1.2.1.1.1.1.3.7.5.1]
b. 22 Mar 1830 d. 24 Jun 1831
10
Mariah Stoddard
[1.2.1.1.1.1.3.7.5.2]
b. 12 Apr 1832 d. 8 Oct 1896
+
William McCleary
b. 9 Oct 1793 d. Jun 1846
9
Samuel Harrison Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.6]
b. 13 Mar 1808 d. 30 Jul 1844
Mary Bailey
b. 20 Dec 1808 d. 25 Jan 1841
10
Susanna Bailey Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.6.1]
b. 27 Oct 1835 d. 14 Dec 1905
10
Mary Bailey Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.6.2]
b. 27 Mar 1837 d. 14 Oct 1916
10
Samuel Harrison Bailey Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.6.3]
b. 1 Aug 1838 d. 12 Jun 1914
10
Lucy Bailey Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.6.4]
b. 6 Jan 1841 d. Jan 1841
Levira Clark
b. 30 Jul 1815 d. 1 Jan 1893
10
Levira Annette Clark Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.6.5]
b. 29 Apr 1842 d. 18 Dec 1888
+
Joseph Fielding Smith
b. 13 Nov 1838 d. 19 Nov 1918
10
Lovisa Clark Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.6.6]
b. 28 Aug 1843 d. Dec 1843
10
Lucy Jane Clark Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.6.7]
b. 20 Aug 1844 d. 1844
9
Ephraim Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.7]
b. 13 Mar 1810 d. 24 Mar 1810
9
William B Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.8]
b. 13 Mar 1811 d. 13 Nov 1893
Carolina Amanda Grant
b. 22 Jan 1814 d. 22 May 1845
10
Mary Jane Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.8.1]
b. 7 Jan 1834 d. 21 Dec 1878
10
Caroline L Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.8.2]
b. Aug 1839 d. 9 Jan 1878
Roxie Ann Grant
b. 16 Mar 1825 d. 30 Mar 1900
10
Thalia Grant Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.8.3]
b. 21 Sep 1848 d. 27 Nov 1924
10
Hyrum Wallace Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.8.4]
b. 17 Aug 1850 d. 27 Jan 1935
Eliza Elise Jane Sanborn
b. 16 Apr 1827 d. 7 Mar 1889
10
William Enoch Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.8.5]
b. 23 Jul 1858 d. 13 Feb 1930
10
Edson Don Carlos Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.8.6]
b. 16 Sep 1862 d. 13 Feb 1939
10
Louise Mae "Loie " Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.8.7]
b. 8 May 1866 d. 10 May 1925
+
Rosella Goyette
b. 16 May 1830 d. 6 Apr 1923
9
Katherine Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.9]
b. 28 Jul 1813 d. 1 Feb 1900
Wilkins Jenkins Salisbury
b. 6 Jan 1809 d. 27 Nov 1853
10
Elizabeth Salisbury
[1.2.1.1.1.1.3.7.9.1]
b. 9 Apr 1832 d. 15 Jul 1832
10
Lucy Salisbury
[1.2.1.1.1.1.3.7.9.2]
b. 3 Oct 1834 d. 18 Oct 1892
10
Reverend Solomon Jenkins Salisbury
[1.2.1.1.1.1.3.7.9.3]
b. 18 Sep 1835 d. 12 Jan 1927
10
Alvin Salisbury
[1.2.1.1.1.1.3.7.9.4]
b. 7 Jun 1838 d. 21 Aug 1880
10
Reverend Don C. Salisbury
[1.2.1.1.1.1.3.7.9.5]
b. 25 Oct 1840 d. 6 Apr 1919
10
Emma C Salisbury
[1.2.1.1.1.1.3.7.9.6]
b. 25 Mar 1844 d. 10 Oct 1846
10
Lorin Ephraim Salisbury
[1.2.1.1.1.1.3.7.9.7]
b. 4 May 1845 d. 18 Nov 1849
10
Frederick Vilian Salisbury
[1.2.1.1.1.1.3.7.9.8]
b. 27 Jan 1850 d. 24 Feb 1934
+
Joseph Younger
b. 1805 d. 1900
9
Don Carlos Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.10]
b. 25 Mar 1816 d. 7 Aug 1841
Agnes Moultin Coolbrith
b. 11 Jul 1811 d. 26 Dec 1876
10
Agnes Charlotte Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.10.1]
b. 7 Aug 1836 d. 31 Jan 1873
10
Sophronia C. Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.10.2]
b. 22 Apr 1838 d. 3 Oct 1843
10
Josephine Donna "Ina Coolbrith" Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.10.3]
b. 10 Mar 1841 d. 29 Feb 1928
Robert Bruce Carsley
b. 6 Jun 1833 d. 14 Aug 1905
11
Son 1 Carsley
[1.2.1.1.1.1.3.7.10.3.1]
b. 1860 d. 1860
11
Son 2 Carsley
[1.2.1.1.1.1.3.7.10.3.2]
b. 1861 d. Bef 1865
9
Lucy Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.11]
b. 18 Jul 1821 d. 9 Dec 1882
Arthur Millikin
b. 9 May 1817 d. 23 Apr 1882
10
Don Carlos Smith Millikin
[1.2.1.1.1.1.3.7.11.1]
b. 13 Oct 1843 d. 26 Nov 1932
10
Sarah M Millikin
[1.2.1.1.1.1.3.7.11.2]
b. 13 Sep 1844 d. 23 Nov 1934
10
George William Dell Millikin
[1.2.1.1.1.1.3.7.11.3]
b. 4 Mar 1848 d. 16 Jan 1913
10
Florence Arabella Millikin
[1.2.1.1.1.1.3.7.11.4]
b. 23 May 1850 d. 21 Oct 1927
10
Julia Amelia Millikin
[1.2.1.1.1.1.3.7.11.5]
b. 17 Jun 1853 d. 7 Jun 1888
10
Frances A. Millikin
[1.2.1.1.1.1.3.7.11.6]
b. 26 Oct 1856 d. 14 Mar 1858
10
Charles Arthur Millikin
[1.2.1.1.1.1.3.7.11.7]
b. 31 Aug 1858 d. 12 May 1884
10
Clara Irene Millikin
[1.2.1.1.1.1.3.7.11.8]
b. 23 Aug 1861 d. 26 Mar 1948
10
Clarence Hyrum Millikin
[1.2.1.1.1.1.3.7.11.9]
b. 26 Mar 1865 d. 5 Apr 1922
9
Joseph Smith, Jr
[1.2.1.1.1.1.3.7.12]
b. 23 Dec 1805 d. 27 Jun 1844
Emma Hale
b. 10 Jul 1804 d. 30 Apr 1879
10
Alvin Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.1]
b. 15 Jun 1828 d. 15 Jun 1828
10
Joseph Murdock Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.2]
b. 30 Apr 1831 d. 29 Mar 1832
10
Julia Murdock Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.3]
b. 30 Apr 1831 d. 12 Sep 1880
+
Elisha Dixon
b. 1827 d. 1850
+
John J Middleton
b. Abt 1827 d. Abt 1869
10
Thaddeus Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.4]
b. 30 Apr 1831 d. 30 Apr 1831
10
Louisa Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.5]
b. 30 Apr 1831 d. 30 Apr 1831
10
Joseph Smith, III
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.6]
b. 6 Nov 1832 d. 10 Dec 1914
Emmeline Griswold
b. 12 Mar 1838 d. 25 Mar 1869
11
Emma Josepha Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.6.1]
b. 28 Jul 1857 d. 30 Nov 1940
Alexander McCallum
b. 4 Apr 1848 d. 8 Oct 1928
12
Joseph Alma McCallum
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.6.1.1]
b. 19 Sep 1878 d. 1967 [
=>
]
12
Arthur Alexander McCallum
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.6.1.2]
b. 2 Jun 1882 d. 27 Mar 1937
12
William James McCallum
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.6.1.3]
b. 1 Aug 1890 d. 10 Oct 1963
12
Oscar MacEo McCallum
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.6.1.4]
b. 12 Jun 1896 d. 20 Feb 1898
11
Evelyn Rebecca Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.6.2]
b. 25 Jan 1859 d. 30 Sep 1859
11
Carrie Lucinda Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.6.3]
b. 15 Sep 1861 d. 27 Apr 1944
Francis Marion Weld
b. 9 Sep 1858 d. 4 Jul 1938
12
Emma Rebecca Weld
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.6.3.1]
b. 3 Jul 1889 d. Abt 1975 [
=>
]
11
Zaide Viola Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.6.4]
b. 25 Apr 1863 d. 8 Jan 1891
Richard Savary Salyards
b. 16 Jun 1857 d. 27 Nov 1944
12
Emma Marie Salyards
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.6.4.1]
b. 8 Aug 1884 d. 16 Sep 1886
12
Zaide Aileen Salyards
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.6.4.2]
b. 11 Jan 1887 d. 27 May 1973
12
Joseph Richard Salyards
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.6.4.3]
b. 18 Aug 1888 [
=>
]
12
Richard Savary Salyards
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.6.4.4]
b. 21 Jun 1890 d. 28 Feb 1988 [
=>
]
11
Joseph Arthur Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.6.5]
b. 12 Aug 1865 d. 12 Mar 1866
Bertha Madison
b. 16 Jul 1843 d. 19 Oct 1896
11
David Carlos Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.6.6]
b. 14 Aug 1870 d. 24 Jan 1886
11
Mary Audentia Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.6.7]
b. 23 Mar 1872 d. 5 May 1963
11
Frederick Madison Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.6.8]
b. 21 Jan 1874 d. 20 Mar 1946
11
Israel Alexander Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.6.9]
b. 2 Feb 1876 d. 14 Jun 1958
11
Kenneth Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.6.10]
b. 6 Oct 1877 d. 6 Oct 1877
11
Bertha Azubah Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.6.11]
b. 15 Oct 1878 d. 14 Oct 1884
11
Hale Washington Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.6.12]
b. 22 Feb 1881 d. 10 Jul 1956
11
Blossom Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.6.13]
b. 1 May 1883 d. 1 May 1883
11
Lucy Yeteve Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.6.14]
b. 11 Dec 1884 d. 4 Aug 1945
Ada Rachel Clark
b. 23 Jul 1871 d. 20 Oct 1915
11
Reginald Archer Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.6.15]
b. 26 Dec 1898 d. 20 Jun 1969
11
William Wallace Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.6.16]
b. 18 Nov 1900 d. 4 Aug 1989
11
Reginald Archer Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.6.17]
b. 8 Jan 1903 d. 28 Sep 1974
10
Frederick Granger Williams Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.7]
b. 20 Jun 1836 d. 13 Apr 1862
Anna Marie Jones
b. 7 Apr 1841 d. 11 Oct 1901
11
Alice Fredericka Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.7.1]
b. 27 Nov 1858 d. 5 Nov 1932
10
Alexander Hale Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8]
b. 2 Jun 1838 d. 12 Aug 1909
Elizabeth Agnes Kendall
b. 16 Jun 1845 d. 7 May 1919
11
Frederick Alexander Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.1]
b. 19 Jan 1862 d. 25 Jun 1954
Mary Angelina Walker
b. 18 Mar 1867 d. 3 Dec 1931
12
Alexander David Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.1.1]
b. 18 Aug 1885 d. 20 Oct 1891
12
Gladys Inez Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.1.2]
b. 17 Dec 1886 d. 17 Jul 1983 [
=>
]
12
Joy May Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.1.3]
b. 13 Jul 1889 d. 29 Jul 1961 [
=>
]
12
Glaud Leslie Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.1.4]
b. 19 Jan 1891 d. 16 Feb 1986 [
=>
]
12
Freda Saloam Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.1.5]
b. 3 Dec 1892 d. 13 Oct 1974
12
Winsome Lavinia Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.1.6]
b. 20 Aug 1896 d. 30 Nov 1986 [
=>
]
12
Frederick Augenstein Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.1.7]
b. 19 Mar 1899 d. Jan 1966
12
Harold Legrand Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.1.8]
b. 12 Jan 1902 d. 19 Jul 1992
+
Margaret Esther Clark
b. 1 Sep 1901 d. 3 Aug 1987
11
Vida Elizabeth Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.2]
b. 16 Jan 1865 d. 3 Jan 1945
Heman Conoman Smith
b. 27 Sep 1850 d. 17 Apr 1919
12
Heman Hale Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.2.1]
b. 28 Apr 1887 d. 11 Mar 1962 [
=>
]
12
Vida Inez Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.2.2]
b. 16 Jan 1889 d. 24 Oct 1964
12
Anna Earlita Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.2.3]
b. 28 Nov 1890 d. 5 Jun 1975 [
=>
]
12
Lois Elizabeth Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.2.4]
b. 3 Nov 1892 d. 27 Mar 1914 [
=>
]
11
Ina Inez Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.3]
b. 22 Nov 1866 d. 18 Aug 1945
Sidney Garden Wright
b. 26 Jul 1869 d. 8 Aug 1936
12
Claud Kendall Wright
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.3.1]
b. 21 Mar 1892 d. 6 Oct 1972 [
=>
]
12
Vida Grace Wright
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.3.2]
b. 22 Apr 1893 d. 11 Jul 1970 [
=>
]
12
Leland Eric Wright
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.3.3]
b. 30 Dec 1895 d. 11 Nov 1977 [
=>
]
12
Mavis Myra Wright
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.3.4]
b. 30 Dec 1897 d. 15 Aug 1960 [
=>
]
12
Warren Alford Wright
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.3.5]
b. 28 Mar 1899 d. 26 Feb 1980 [
=>
]
12
Edgar Milton Wright
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.3.6]
b. 1 May 1901 d. 2 May 1961 [
=>
]
12
Glory Carmen Wright
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.3.7]
b. 14 Aug 1903 d. 4 Nov 1968
12
Byron Granville Wright
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.3.8]
b. 19 Feb 1906 d. 3 Nov 1974 [
=>
]
12
Marian Inez Wright
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.3.9]
b. 17 Nov 1907 d. 28 Jul 1987 [
=>
]
12
Gwen Hero Wright
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.3.10]
b. 23 Oct 1909 d. 28 Jul 1987
11
Emma Belle Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.4]
b. 17 Mar 1869 d. 3 May 1960
William Forrester Kennedy
b. 5 Jun 1863 d. 22 Mar 1938
12
Arthur Frederick Kennedy
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.4.1]
b. 25 May 1889 d. 1 Jul 1889
12
Joseph Douglas Kennedy
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.4.2]
b. 14 Oct 1891 d. 14 Oct 1891
12
Cecile Grace Kennedy
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.4.3]
b. 3 Jun 1894 d. 9 May 1895
12
Roger Alexander Kennedy
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.4.4]
b. 5 Nov 1897 d. 15 Dec 1933 [
=>
]
12
Glenna Marie Kennedy
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.4.5]
b. 3 Nov 1900 d. 30 Jul 1986
11
Don Alvin Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.5]
b. 17 May 1871 d. 8 Sep 1904
Susan Zeanette Pearsall
b. 21 Apr 1873 d. 22 Jun 1957
12
Velora Belle Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.5.1]
b. 13 Dec 1893 d. 28 Dec 1993
12
Carlos McAllister Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.5.2]
b. 22 May 1895 d. Nov 1981 [
=>
]
12
Beatrice Adelle Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.5.3]
b. 19 Aug 1896 d. 21 Jun 1989 [
=>
]
12
LaJune Harriet Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.5.4]
b. 1 Jul 1899 d. 9 Aug 1985
12
Don Marion Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.5.5]
b. 28 Oct 1901 d. 13 Nov 1983 [
=>
]
12
Maxwell Alexis Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.5.6]
b. 13 Apr 1903 d. 17 Feb 1961 [
=>
]
11
Eva Grace Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.6]
b. 1 Mar 1874 d. 26 Mar 1893
Forrest Lamont Madison
b. 1872 d. 18 Mar 1945
12
Lamont Kendall Madison
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.6.1]
b. 17 Mar 1893 d. 3 Apr 1963 [
=>
]
11
Joseph George Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.7]
b. 7 May 1877 d. 27 Dec 1936
Nellie May Daudelin
b. 19 Jun 1879 d. 2 Apr 1935
12
Josephine Alexandria Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.7.1]
b. 20 Nov 1904 d. 6 Aug 1985 [
=>
]
12
Paul Daudelin Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.7.2]
b. 1 Mar 1908 d. Sep 1975
11
Arthur Marion Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.8]
b. 8 Feb 1880 d. 21 Mar 1964
Estella Almira Danielson
b. 7 Mar 1884 d. 23 Jun 1916
12
Verl Marion Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.8.1]
b. 21 Apr 1905 d. 3 Aug 1980
12
Carl K Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.8.2]
b. 5 Mar 1907 d. 1966
12
Alexander Martin Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.8.3]
b. 7 Feb 1909 d. 30 Sep 1982 [
=>
]
12
Kenneth Julian Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.8.4]
b. 7 Mar 1911 d. 16 Jun 1988 [
=>
]
12
Arthur Granger Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.8.5]
b. 18 Mar 1916 d. 17 Mar 2012
Minnie Catherine Smith
b. 20 May 1894 d. 30 Jan 1988
12
Georgia May Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.8.6]
b. 22 Feb 1923 d. Jul 2009 [
=>
]
12
Myrle Lee Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.8.7]
b. 14 Sep 1925 d. 21 Nov 1985
11
Coral Cecil Rebekah Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.9]
b. 29 Oct 1882 d. 17 Aug 1968
Louis Hurst Horner
b. 21 Sep 1878 d. 18 Feb 1970
12
Louis Brainard Horner
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.9.1]
b. 26 Oct 1906 d. 13 Aug 1980
12
Elizabeth Grace Horner
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.9.2]
b. 16 Apr 1910 d. 19 Jul 1991 [
=>
]
12
James Brandon Horner
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.9.3]
b. 5 Jul 1912 d. 23 Jan 1975
12
Ina Lorena Horner
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.8.9.4]
b. 30 Aug 1915 d. 1 Dec 2004 [
=>
]
10
Don Carlos Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.9]
b. 13 Jun 1840 d. 15 Sep 1841
10
Thomas Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.10]
b. 6 Feb 1842 d. 6 Feb 1842
10
David Hyrum Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.11]
b. 17 Nov 1844 d. 29 Aug 1904
Clara Charlotte Hartshorn
b. 18 May 1851 d. 9 Aug 1926
11
Elbert Aoriul Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.11.1]
b. 8 Mar 1871 d. 15 May 1959
Clara Abigale Cochran
b. 12 Jan 1874 d. 30 Oct 1948
12
Lawrence David Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.11.1.1]
b. 3 Jun 1896 d. 17 Jun 1896
12
Ronald Gibson Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.11.1.2]
b. 10 Oct 1902 d. 4 Feb 1988
12
Lynn Elbert Smith
[1.2.1.1.1.1.3.7.12.11.1.3]
b. 20 Jan 1911 d. 1 Jun 1992 [
=>
]
+
Agnes Moultin Coolbrith
b. 11 Jul 1811 d. 26 Dec 1876
+
Fanny Young
b. 8 Nov 1787 d. 11 Jun 1859
+
Eliza Roxey Snow
b. 21 Jan 1804 d. 5 Dec 1887
+
Francis Ward "Fanny" Alger
b. 30 Sep 1817 d. 29 Nov 1889
+
Louisa Beaman
b. 7 Feb 1815 d. 15 May 1850
+
Helen Mar Kimball
b. 25 Aug 1828 bur. 15 Nov 1896
+
Emily Dow Partridge
b. 28 Feb 1824 d. 9 Dec 1899
+
Olive Grey Frost
b. 24 Jul 1816 d. 8 Oct 1845
+
Rhoda Richards
b. 8 Aug 1784 d. 17 Jan 1879
+
Lucy Walker
b. 30 Apr 1826 d. 1 Oct 1910
+
Sarah Ann Whitney
b. 22 Mar 1825 d. 4 Sep 1873
+
Prescinda Lothrop Huntington
b. 7 Sep 1810 d. 1 Feb 1892
+
Eliza Partridge
b. 20 Apr 1820 bur. 2 Mar 1886
+
Desdemona Wadsworth Fullmer
b. 6 Oct 1809 d. 9 Feb 1886
+
Zina Diantha Huntington
b. 31 Jan 1821 d. 28 Aug 1901
+
Mary Elizabeth Rollins
b. 9 Apr 1818 d. 17 Dec 1913
+
Martha McBride
b. 17 Mar 1805 d. 20 Nov 1901
+
Sylvia Porter Sessions
b. 31 Jul 1818 d. 12 Apr 1882
+
Patty Bartlett
b. 4 Feb 1795 d. 14 Dec 1892
+
Maria Lawrence
b. 18 Dec 1823 d. 1847
+
Sarah A Lawrence
b. 13 May 1826 d. 28 Nov 1872
7
Hannah MacK
[1.2.1.1.1.1.4]
b. 15 Oct 1734
7
Samuel Mack
[1.2.1.1.1.1.5]
b. 15 Nov 1736 d. 10 Oct 1783
7
Hephzibah Mack
[1.2.1.1.1.1.6]
b. 7 May 1740 d. 15 Jun 1818
7
Stephen Mack
[1.2.1.1.1.1.7]
b. 15 Jun 1742 d. 25 Sep 1762
7
Elisha Huntley Mack
[1.2.1.1.1.1.8]
b. 16 Jul 1745 d. 15 Nov 1820
7
Azubah Mack
[1.2.1.1.1.1.9]
b. 28 Nov 1748 d. 12 Jun 1816
6
Aaron Huntley, III
[1.2.1.1.1.2]
b. 14 Sep 1710 d. 18 Nov 1763
6
Solomon Huntley
[1.2.1.1.1.3]
b. 1 Sep 1712
6
Deborah Huntley
[1.2.1.1.1.4]
b. 20 Aug 1714 d. 26 Mar 1807
6
Ruth Huntley
[1.2.1.1.1.5]
b. 1 Mar 1716 d. 15 Jun 1805
6
Stephen Huntley
[1.2.1.1.1.6]
b. 28 Feb 1719 d. 15 Jun 1805
6
Phebe Huntley
[1.2.1.1.1.7]
b. 1 Mar 1721 d. 1797
6
Esther Huntley
[1.2.1.1.1.8]
b. 21 May 1724 d. 15 Jun 1805
6
Nathan Huntley
[1.2.1.1.1.9]
b. 2 Jun 1726 d. 30 Apr 1798
6
Jemima Huntley
[1.2.1.1.1.10]
b. 30 Aug 1728 d. Aft 1854
6
Timothy Huntley
[1.2.1.1.1.11]
b. 22 Oct 1731 d. 26 Sep 1738
5
Benjamin DeWolf
[1.2.1.1.2]
b. Oct 1695 d. 1742
5
Lewis DeWolf
[1.2.1.1.3]
b. 5 Jun 1698 d. 1742
5
Phebe DeWolf
[1.2.1.1.4]
b. 5 Jun 1701
4
Margaret Jones
[1.2.1.2]
b. 15 Aug 1667 d. 17 Jan 1738
4
Mary Jones
[1.2.1.3]
b. 3 Dec 1670 d. 7 Jan 1739
4
Katherine Jones
[1.2.1.4]
b. 28 May 1671 d. 17 Jan 1738
4
Jonathan Jones
[1.2.1.5]
b. 12 Nov 1673 d. 17 Jan 1738
4
Samuel Jones
[1.2.1.6]
b. 18 May 1676 d. 17 Jan 1738
4
Ephraim Jones
[1.2.1.7]
b. 1 May 1685 d. 11 Sep 1734
3
Lydia Ann Jones
[1.2.2]
b. 3 Jul 1636 d. 3 Feb 1701
3
Simon Jones
[1.2.3]
b. 1639
3
Josiah Jones
[1.2.4]
b. 1640
3
Nathaniel Jones
[1.2.5]
b. 1642 d. May 1688
3
Phoebe Jones
[1.2.6]
b. 21 Jan 1646 d. 6 Jul 1650
3
Shubael Jones
[1.2.7]
b. 1 Jul 1651 d. 11 Apr 1684
3
Captain Josiah Jones
[1.2.8]
b. 2 Oct 1643 d. 9 Oct 1714
Lydia Treadway
b. 1 Sep 1649 d. 18 Sep 1743
4
Lydia Jones
[1.2.8.1]
b. 25 Jun 1668 d. 21 May 1718
4
Captian Josiah Jones
[1.2.8.2]
b. 20 Oct 1670 d. 21 Dec 1734
Abigail Barnes
b. 14 Jun 1671 d. 4 Nov 1749
5
Daniel Jones
[1.2.8.2.1]
b. 2 Feb 1692 d. 18 Jun 1740
5
Abigail Jones
[1.2.8.2.2]
b. 11 Sep 1694 d. 4 Dec 1784
5
Josiah Jones
[1.2.8.2.3]
b. 24 Oct 1701 d. 22 Mar 1769
5
William Jones
[1.2.8.2.4]
b. 4 Jan 1706 d. 26 Jan 1761
5
Elisha Jones
[1.2.8.2.5]
b. 20 Nov 1710 d. 15 Feb 1775
Mary Allen
b. 13 Dec 1714 d. 26 Mar 1751
6
Nathan Jones
[1.2.8.2.5.1]
b. 26 Sep 1734 d. 7 May 1806
6
John Jones
[1.2.8.2.5.2]
b. Abt 1735 d. 1735
6
Elisha Jones, Jr
[1.2.8.2.5.3]
b. 9 Jan 1736 d. 1783
6
Israel Jones
[1.2.8.2.5.4]
b. 21 Sep 1738 d. 1825
6
Daniel Jones
[1.2.8.2.5.5]
b. 25 Jul 1740 d. 1786
6
Elias Jones
[1.2.8.2.5.6]
b. 19 Aug 1742 d. 1786
6
Josiah Jones
[1.2.8.2.5.7]
b. 9 Nov 1744 d. 1825
6
Silas Jones
[1.2.8.2.5.8]
b. 7 Nov 1746 d. 9 Dec 1754
6
Mary Jones
[1.2.8.2.5.9]
b. 11 Jun 1748 d. 2 Aug 1830
Asa Dunbar
b. 26 May 1745 d. 22 Jun 1787
7
William Dunbar
[1.2.8.2.5.9.1]
b. 28 Sep 1776 d. 6 Jul 1779
7
Charles Dunbar
[1.2.8.2.5.9.2]
b. 24 Feb 1780
7
Sophia Dunbar
[1.2.8.2.5.9.3]
b. 19 Jul 1781 d. 6 Jul 1868
7
Louisa Dunbar
[1.2.8.2.5.9.4]
b. 11 May 1785
7
Cynthia Dunbar
[1.2.8.2.5.9.5]
b. 22 May 1787 d. 12 Mar 1872
John Thoreau
b. 8 Oct 1787 d. 3 Feb 1859
8
Helen Louisa Thoreau
[1.2.8.2.5.9.5.1]
b. 22 Oct 1812 d. 1849
8
John Thoreau, Jr
[1.2.8.2.5.9.5.2]
b. 1815 d. 11 Jan 1842
8
David Henry Thoreau
[1.2.8.2.5.9.5.3]
b. 12 Jul 1817 d. 6 May 1862
8
Sophia Elizabeth Thoreau
[1.2.8.2.5.9.5.4]
b. 24 Jun 1819 d. 7 Oct 1876
6
Ephraim Jones
[1.2.8.2.5.10]
b. 17 Apr 1750 d. 24 Jan 1812
6
Simeon Jones
[1.2.8.2.5.11]
b. 5 Dec 1751 d. 14 Aug 1823
6
Stephen Jones
[1.2.8.2.5.12]
b. 5 Mar 1754 d. 20 Aug 1830
6
Jonas Jones
[1.2.8.2.5.13]
b. 16 Aug 1756 d. 1856
6
Philaman Jones
[1.2.8.2.5.14]
b. 11 Feb 1759 d. 24 Feb 1759
6
Charles Jones
[1.2.8.2.5.15]
b. 27 Jan 1760 d. 1765
4
Mary Hannah Jones
[1.2.8.3]
b. 10 Dec 1672 d. 11 Apr 1729
4
Captain Nathaniel Jones
[1.2.8.4]
b. 31 Dec 1674 d. 21 Nov 1745
4
Samuel Jones
[1.2.8.5]
b. 9 Jul 1677 d. 25 Jan 1717/1718
4
Anne Jones
[1.2.8.6]
b. 28 Jun 1684 d. 1736
4
John Jones
[1.2.8.7]
b. 19 Mar 1686 d. 9 Dec 1773
4
Isaac Jones
[1.2.8.8]
b. 25 May 1690 d. 18 Feb 1782