Home Page
|
What's New
|
Photos
|
Histories
|
Headstones
|
Reports
|
Surnames
Search
First Name:
Last Name:
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Suomalainen
Svenska
Sir Richard Austin
1458 - 1554 (96 years)
Submit Photo / Document
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Submit Photo / Doc
Worksheet
Family
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Sir Richard Austin
[1]
b. 1458 d. 1554
Elizabeth Preston
b. 1460 d. 27 Nov 1557
2
Richard Austin
[1.1]
b. Abt 1478 d. 1505
2
Elizabeth Austin
[1.2]
b. 1479 d. 1530
2
Maxwell Joshua Austin
[1.3]
b. 1480 d. 17 Nov 1557
2
John Austen
[1.4]
b. Abt 1483 d. 1532
2
Sir Stephen Austin
[1.5]
b. 1484 d. 17 Nov 1557
Margaret Dorigley
b. 1497 d. 5 Feb 1550
3
Stephen Austin
[1.5.1]
b. 22 Apr 1520 d. 25 Feb 1558
Elizabeth Bassock
b. 1527 bur. 17 Mar 1563
4
Joanne Austin
[1.5.1.1]
b. 1 Jan 1553 d. 28 Oct 1586
Henry Harris
b. 1552 d. 20 Nov 1616
5
John Harris
[1.5.1.1.1]
b. 14 Jul 1580 d. 19 Jul 1609
5
Dorytye Harris
[1.5.1.1.2]
b. Abt 1582 d. 27 Apr 1589
5
Sara Harris
[1.5.1.1.3]
b. 26 Apr 1584
5
Andrew Harris
[1.5.1.1.4]
b. 6 Jun 1585 d. Bef 2 Nov 1616
Jane Bagley
b. Abt 1584 d. 11 Apr 1676
6
Thomas Harris
[1.5.1.1.4.1]
b. 12 Apr 1605 d. 7 Jun 1686
Elizabeth Cutter
b. 22 Apr 1608 d. 1 Sep 1687
7
William Harris
[1.5.1.1.4.1.1]
b. 1633
Edith Bligh
b. 1620 d. 5 Aug 1685
8
Martha Harris
[1.5.1.1.4.1.1.1]
b. Abt 1642 d. 14 Jul 1710
Joseph Coit
b. 1630 d. 27 Mar 1704
9
John Coit
[1.5.1.1.4.1.1.1.1]
b. 1 Dec 1670 d. 22 Oct 1744
9
Joseph Coit
[1.5.1.1.4.1.1.1.2]
b. 4 Apr 1673 d. 1 Jul 1750
Elisabeth Wheeler
b. 22 May 1683 bur. 14 Apr 1735
10
Colonel Samuel Coit
[1.5.1.1.4.1.1.1.2.1]
b. 1707 d. 4 Oct 1792
10
Joseph Coit
[1.5.1.1.4.1.1.1.2.2]
b. Abt 1711 d. 21 Jul 1741
10
Abigail Coit
[1.5.1.1.4.1.1.1.2.3]
b. 18 Apr 1712 d. 27 Aug 1799
Thomas Gates
b. 15 Jun 1709 d. 28 Nov 1784
11
Abigail Gates
[1.5.1.1.4.1.1.1.2.3.1]
b. 31 Dec 1735
Charles Spaulding
b. 12 Dec 1735 d. 15 Mar 1807
12
Dutee Spaulding
[1.5.1.1.4.1.1.1.2.3.1.1]
b. 29 Nov 1765 d. 4 Dec 1840
12
Daniel L Spaulding
[1.5.1.1.4.1.1.1.2.3.1.2]
b. 8 Aug 1767 d. 8 Aug 1817
12
Anna N Spaulding
[1.5.1.1.4.1.1.1.2.3.1.3]
b. 1770 d. 1825 [
=>
]
12
Maxwell Spaulding
[1.5.1.1.4.1.1.1.2.3.1.4]
b. Abt 1771
12
Dorothy Spaulding
[1.5.1.1.4.1.1.1.2.3.1.5]
b. Abt 1772
12
Eunice Spaulding
[1.5.1.1.4.1.1.1.2.3.1.6]
b. Abt 1772 d. 6 Jun 1829
12
Thomas Spalding
[1.5.1.1.4.1.1.1.2.3.1.7]
b. 1775
12
Abigail Spalding
[1.5.1.1.4.1.1.1.2.3.1.8]
b. Abt 1776
12
Experience Spaulding
[1.5.1.1.4.1.1.1.2.3.1.9]
b. 1778 d. 26 Sep 1841
10
Martha Colt
[1.5.1.1.4.1.1.1.2.4]
b. Abt 1713
10
Isaac Coit
[1.5.1.1.4.1.1.1.2.5]
b. 26 Dec 1714 d. 23 Apr 1776
10
Mary Colt
[1.5.1.1.4.1.1.1.2.6]
b. 1717
10
William Coit
[1.5.1.1.4.1.1.1.2.7]
b. 1720 d. Bef 1776
10
Daniel Coit
[1.5.1.1.4.1.1.1.2.8]
b. Abt 1724 d. 14 Apr 1762
10
Experience Wheeler Coit
[1.5.1.1.4.1.1.1.2.9]
b. Abt 1726 d. 20 Feb 1767
9
William Coit
[1.5.1.1.4.1.1.1.3]
b. 25 Jan 1675 d. 7 May 1703
9
Solomon Coit
[1.5.1.1.4.1.1.1.4]
b. 29 Nov 1679 d. Abt 1753
9
Samuel Coit
[1.5.1.1.4.1.1.1.5]
b. Abt 1692 d. 28 Feb 1753
8
Mary Harris
[1.5.1.1.4.1.1.2]
b. 1 Jul 1645 d. 30 Aug 1721
8
Hannah Harris, I
[1.5.1.1.4.1.1.3]
b. 1 Mar 1646 d. 3 Aug 1722
8
Patience Harris
[1.5.1.1.4.1.1.4]
b. Abt 1648 d. 19 Mar 1732
8
Elizabeth Harris
[1.5.1.1.4.1.1.5]
b. Abt 1649 d. 7 Oct 1694
7
Eleanor Harris
[1.5.1.1.4.1.2]
b. 1635 d. 28 Jun 1650
7
Mary Harris
[1.5.1.1.4.1.3]
b. 1639 d. 14 Dec 1722
Samuel Whipple
c. 17 Mar 1644 d. 12 Mar 1711
8
Noah Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.1]
b. Abt 1667 d. 10 Nov 1703
Susannah
b. Abt 1665
9
Susannah Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.1.1]
b. Abt 1691 d. 21 Jan 1720
9
Abraham Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.1.2]
b. 1693
9
Noah Whipple, Jr
[1.5.1.1.4.1.3.1.3]
b. 18 Dec 1697 d. 29 Feb 1784
Mary Dexter
b. 1699
10
Freelove Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.1]
b. 1736
Benjamin Pitts
b. 6 Nov 1754
11
James Pitts
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.1.1]
b. 5 Dec 1780
11
Marcy Whipple Pitts
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.1.2]
b. 14 Dec 1783
10
Susannah Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.2]
b. Abt 1723 d. 1804
Elisha Angell
b. 13 Oct 1719 d. 14 Nov 1755
11
Enoch Angell
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.2.1]
b. 15 Oct 1742 d. 17 Feb 1832
Amey Randall
b. Abt May 1751 d. 17 Dec 1767
12
Randall Angell
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.2.1.1]
b. 30 Nov 1767 d. 5 Sep 1855 [
=>
]
Freelove Randall
b. 16 Jun 1749 d. 7 Feb 1778
12
Elisha Angell
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.2.1.2]
b. 21 May 1770 d. 25 Feb 1846 [
=>
]
12
Stephen Angell
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.2.1.3]
b. Abt 20 Mar 1776 d. 1 Feb 1818
12
Nathaniel Angel
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.2.1.4]
b. 12 Mar 1780 d. 3 Aug 1832 [
=>
]
11
Mary Angel
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.2.2]
b. 4 Oct 1744
Jonathan Comstock
b. 7 Sep 1737 d. 4 Dec 1784
12
Felix Comstock
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.2.2.1]
b. 1770 d. 22 Jul 1822
12
Thomas Comstock
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.2.2.2]
b. 7 May 1775 d. 7 Sep 1834
12
Ichabod Comstock
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.2.2.3]
b. 1776 bur. Jan 1775
12
Lucy Comstock
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.2.2.4]
b. 1778
11
Abner Angell
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.2.3]
b. 1746
+
Almyra Whitman
b. 1782
11
Martha Angell
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.2.4]
b. Abt 19 May 1750 d. 8 Jun 1790
David Soule
b. 1741
12
Thomas Soule
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.2.4.1]
b. 1784
12
Constant Soule
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.2.4.2]
b. 14 May 1785
12
Samuel Soule
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.2.4.3]
b. 1796
11
Isaac Angell
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.2.5]
b. 17 Jul 1753 d. 9 Dec 1831
Salley Williams
b. 1760
12
James Angell
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.2.5.1]
b. Abt 1781 d. 20 Nov 1870
12
Susanna Angell
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.2.5.2]
b. 12 May 1782 d. 22 May 1837
12
Robert Angell
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.2.5.3]
b. 15 Mar 1786 d. 14 Nov 1862
12
Anna Angell
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.2.5.4]
b. Dec 1788 d. 14 Apr 1832
12
Sarah Williams Angell
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.2.5.5]
b. Abt 12 Feb 1791 d. 20 Jul 1810
12
Elizabeth Williams Angell
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.2.5.6]
b. Abt 6 May 1793 d. 25 Oct 1810
James Angell
b. 31 May 1731 d. Jun 1806
11
Sally Angell
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.2.6]
b. 30 Oct 1757
10
Mary Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.3]
b. Abt 1729 d. 12 Sep 1805
10
Commodore Abraham Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.4]
b. 26 Sep 1732 d. 27 May 1819
Sarah Hopkins
b. 26 Sep 1739 d. 14 Oct 1818
11
Catherine Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.4.1]
b. Abt 1762 d. 1834
Ebenezer Sproat
b. 9 Feb 1752 d. 29 Aug 1819
12
Sarah Whipple Sproat
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.4.1.1]
b. 28 Jan 1782 d. 22 Jan 1851
11
Captain John Hopkins Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.4.2]
b. 2 Jul 1765
11
Mary Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.4.3]
b. Abt 1767 d. 15 Aug 1831
Ezekiel Comstock
b. 17 Jan 1762 d. Abt 27 Feb 1828
12
Elizabeth Carter Comstock
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.4.3.1]
b. 1792 d. 29 Sep 1822
12
Sarah Ann Comstock
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.4.3.2]
b. 21 Jan 1795 d. 29 Sep 1854
12
William Whipple Comstock
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.4.3.3]
b. 23 Mar 1801 d. 20 Oct 1878
10
Samuel Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.5]
b. Abt 1740 d. 6 Feb 1827
Elizabeth Snow
b. 28 Sep 1739 d. 22 Sep 1806
11
Noah Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.5.1]
b. 15 Feb 1772
11
Samuel Whipple, Jr
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.5.2]
b. 4 Jul 1774 d. 9 Nov 1843
Mary Chaffee
b. 1779 d. 12 Mar 1828
12
Lucy A Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.5.2.1]
b. 4 May 1800 d. 18 Apr 1887
12
John N Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.5.2.2]
b. 1801 d. 29 Dec 1865
12
Joseph H Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.5.2.3]
b. 3 May 1803 d. 1 Aug 1891
12
Sarepta Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.5.2.4]
b. 16 Aug 1808 d. 5 Nov 1840
12
Sabrina Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.5.2.5]
b. 1808 d. 1900
12
Reuben Chaffee Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.5.2.6]
b. 1809 d. 21 Jan 1828
12
Jonathan C Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.5.2.7]
b. 1811
12
Mary Ann Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.5.2.8]
b. 1814
12
Samuel A Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.5.2.9]
b. 1815 d. 1886
12
Gustavus A Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.5.2.10]
b. 1816
12
Elizabeth S Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.5.2.11]
b. 1822
12
Martha B Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.5.2.12]
b. 1823 d. 1894
11
Sarah Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.5.3]
b. 1776 d. 21 Jan 1824
Aaron Rice
b. 11 Nov 1768 d. 11 Jul 1822
12
Samuel Rice
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.5.3.1]
b. 20 Apr 1798 d. 10 Oct 1892
12
Harvey Rice
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.5.3.2]
b. 1800 d. 23 Sep 1848
12
Harriet Rice
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.5.3.3]
b. 13 Aug 1805 d. 31 Mar 1867
12
Roxanna Rice
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.5.3.4]
b. 1808
12
Sabrina Celestina Rice
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.5.3.5]
b. 1810 d. 1863
12
Sally Rice
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.5.3.6]
b. 1811
12
Willard Rice
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.5.3.7]
b. 1812
12
Sarah Rice
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.5.3.8]
b. 1814 d. 22 Apr 1833
12
Anna Rice
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.5.3.9]
b. 1816
11
Hopestill Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.1.3.5.4]
b. 3 Oct 1778 d. 21 Mar 1860
9
Daniel Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.1.4]
b. Abt 1703 d. 29 Dec 1789
Mary Smith
b. 3 Aug 1704
10
Mercy Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.1.4.1]
b. 20 Jan 1726 d. 7 Dec 1815
10
Enock Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.1.4.2]
b. Abt 1729
10
Jonathan Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.1.4.3]
b. Abt 1731 d. 13 Apr 1805
10
Mary Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.1.4.4]
b. Abt 1735 d. 6 Dec 1823
Oliver Blackinton
b. 1734 d. 16 Dec 1811
11
Othneil Blackinton
[1.5.1.1.4.1.3.1.4.4.1]
b. 10 May 1758 d. 20 Aug 1804
Chloe Holmes
b. 7 May 1760 d. 18 Apr 1825
12
Ellis Blackinton
[1.5.1.1.4.1.3.1.4.4.1.1]
b. 18 Mar 1783 d. 1870 [
=>
]
12
Lemuel W Blackinton
[1.5.1.1.4.1.3.1.4.4.1.2]
b. 8 Jun 1785 d. 2 Jul 1868 [
=>
]
12
Charlotte G Blackinton
[1.5.1.1.4.1.3.1.4.4.1.3]
b. 2 Mar 1796 d. 6 Jan 1863
12
Eliza Blackinton
[1.5.1.1.4.1.3.1.4.4.1.4]
b. 7 Oct 1802 d. 1882 [
=>
]
11
Oliver Blackinton
[1.5.1.1.4.1.3.1.4.4.2]
b. 13 Feb 1761 d. 3 Apr 1810
Molly Daggett
b. 21 May 1766 d. 1829
12
Catherine Blackinton
[1.5.1.1.4.1.3.1.4.4.2.1]
b. 22 Jan 1785 d. 2 Aug 1862 [
=>
]
12
Levi W Blackinton
[1.5.1.1.4.1.3.1.4.4.2.2]
b. 2 Aug 1788 d. 18 Jul 1851 [
=>
]
12
Nancy Blackinton
[1.5.1.1.4.1.3.1.4.4.2.3]
b. 23 Dec 1790 d. 18 Oct 1868 [
=>
]
12
Mary Blackinton
[1.5.1.1.4.1.3.1.4.4.2.4]
b. 26 Jun 1793
12
Olive D Blackinton
[1.5.1.1.4.1.3.1.4.4.2.5]
b. 7 Sep 1795 d. 25 Oct 1847 [
=>
]
12
Azuba Blackinton
[1.5.1.1.4.1.3.1.4.4.2.6]
b. 15 Dec 1797 d. 9 May 1832 [
=>
]
12
Oliver Blackinton
[1.5.1.1.4.1.3.1.4.4.2.7]
b. 6 Aug 1800
12
Aaron Blackinton
[1.5.1.1.4.1.3.1.4.4.2.8]
b. 8 Apr 1803
12
Chloe Blackinton
[1.5.1.1.4.1.3.1.4.4.2.9]
b. 13 Jul 1805 d. 1854 [
=>
]
11
Levi Blackinton
[1.5.1.1.4.1.3.1.4.4.3]
b. 23 Jun 1763 d. 1783
11
Aaron Blackinton
[1.5.1.1.4.1.3.1.4.4.4]
b. 28 Mar 1774 d. 2 Dec 1802
Sarah Aldis
b. 3 Mar 1773 d. 1849
12
Esther Blackinton
[1.5.1.1.4.1.3.1.4.4.4.1]
b. 9 Dec 1798 [
=>
]
12
Caroline Blackinton
[1.5.1.1.4.1.3.1.4.4.4.2]
b. 20 May 1801
11
Olive Blackinton
[1.5.1.1.4.1.3.1.4.4.5]
b. 8 Dec 1755 d. 14 Nov 1827
Henry Richardson
b. 7 Aug 1752 d. 4 Nov 1827
12
Olive Blackinton "Ollie" Richardsen
[1.5.1.1.4.1.3.1.4.4.5.1]
b. 20 Aug 1775 d. Aft 1850 [
=>
]
12
Henry Richardson
[1.5.1.1.4.1.3.1.4.4.5.2]
b. 29 Nov 1777 d. 24 Jul 1836 [
=>
]
12
Otis Richardson
[1.5.1.1.4.1.3.1.4.4.5.3]
b. 6 Dec 1780 d. 15 Jan 1878 [
=>
]
12
George Washington Richardson
[1.5.1.1.4.1.3.1.4.4.5.4]
b. 31 May 1783 d. 27 Jul 1840 [
=>
]
12
Mary Polly Richardson
[1.5.1.1.4.1.3.1.4.4.5.5]
b. 16 Aug 1786
12
Oliver Blackinton Richardson
[1.5.1.1.4.1.3.1.4.4.5.6]
b. 9 Mar 1789 d. 1874 [
=>
]
12
Betsy Richardson
[1.5.1.1.4.1.3.1.4.4.5.7]
b. 18 Jun 1792 d. Bef 1876 [
=>
]
12
Anteny Wane Richardson
[1.5.1.1.4.1.3.1.4.4.5.8]
b. 20 Jun 1795 d. 1859 [
=>
]
10
Sarah Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.1.4.5]
b. 19 Jun 1737 d. 31 Jul 1812
10
Amey Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.1.4.6]
b. Abt 1739
10
Abigail Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.1.4.7]
b. 11 Oct 1740 d. 5 Mar 1820
10
Hope Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.1.4.8]
b. Abt 1741
+
Anphillis Smith
b. Abt 1660 d. 1715
8
Samuel Whipple, Jr
[1.5.1.1.4.1.3.2]
b. 11 Aug 1669 d. 19 Apr 1728
Elizabeth Eddy
b. 3 Aug 1670 d. 14 Mar 1718
9
Alice Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.1]
b. 10 Apr 1693 d. 19 Apr 1728
9
Samuel Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.2]
b. 10 Apr 1693 d. Bef 1695
9
Samuel Whipple, III
[1.5.1.1.4.1.3.2.3]
b. 8 Nov 1695 d. Bef Jan 1760
Ruth Card
b. 3 Aug 1700
10
Samuel Whipple, IV
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.1]
b. 1722 d. 24 Apr 1794
Eunice Mitchell
b. 1717 d. 24 Apr 1794
11
Noah Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.1.1]
b. 10 Jan 1742 d. Abt 17 Jun 1774
Hope Whipple
b. 7 Feb 1740 d. 28 Mar 1829
12
Eunice Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.1.1.1]
b. 16 Jun 1764 [
=>
]
12
Samuel Stillman Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.1.1.2]
b. 28 Jun 1766 d. 23 Mar 1843 [
=>
]
12
Jonathan Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.1.1.3]
b. 14 Aug 1769 d. Jan 1795 [
=>
]
12
Noah Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.1.1.4]
b. 9 Aug 1771
12
Silas Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.1.1.5]
b. 25 Jul 1773 d. 1835 [
=>
]
11
Lucretia Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.1.2]
b. 18 Nov 1744 d. 30 Jul 1814
Daniel Kennedy
b. 1743 d. 28 Jan 1792
12
Mary Kennedy
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.1.2.1]
b. 10 Sep 1765 [
=>
]
12
Euince Kennedy
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.1.2.2]
b. Abt 1766 d. 6 Oct 1849 [
=>
]
12
Ann Kennedy
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.1.2.3]
b. 17 Nov 1769
12
Lucretia Whipple Kennedy
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.1.2.4]
b. 28 Apr 1773 d. 22 Sep 1845 [
=>
]
12
Alice Kennedy
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.1.2.5]
b. 31 May 1775
12
John Kennedy
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.1.2.6]
b. 1777 d. 22 Jun 1851
12
Elisabeth Kennedy
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.1.2.7]
b. 1779 d. 25 Aug 1814 [
=>
]
11
Joseph Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.1.3]
b. 12 Dec 1748 d. 31 Aug 1799
Jennet Campbell
b. Abt 1752 d. 17 Oct 1840
12
Mary Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.1.3.1]
b. 4 Apr 1774 d. 22 Dec 1842 [
=>
]
11
Jonathan Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.1.4]
b. 26 Apr 1750 d. Abt 1828
+
Lucretia Perone
b. 1752
11
Peronne Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.1.5]
b. 5 Apr 1752 d. 10 Sep 1817
Jonathan Church
b. 7 Apr 1747 d. 23 Dec 1827
12
Daniel Whipple Church
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.1.5.1]
b. 10 May 1772 d. 7 Jan 1857 [
=>
]
12
Eunice Church
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.1.5.2]
b. 14 Aug 1773 [
=>
]
12
Lucy Church
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.1.5.3]
b. 19 Jun 1776
12
Ezra Church
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.1.5.4]
b. 7 May 1778 d. Abt 1859 [
=>
]
12
Cyrus Church
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.1.5.5]
b. 19 Feb 1782 d. 26 Dec 1868
12
Clarissa Church
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.1.5.6]
b. 7 Mar 1784 d. Abt 1870
12
Jonathan Church
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.1.5.7]
b. 27 Jul 1786 d. 12 Sep 1788
12
Horace Church
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.1.5.8]
b. 1 Oct 1788 d. 2 Jul 1792
12
Urania Church
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.1.5.9]
b. 18 Feb 1792 d. 12 Nov 1792
12
Eleanor Church
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.1.5.10]
b. 10 Jan 1780 d. Oct 1828 [
=>
]
11
Alice Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.1.6]
b. 5 Jan 1754
+
Silas Smith
b. 1750
11
Elizabeth Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.1.7]
b. 8 Jun 1756
+
Benjamin Church
b. 20 May 1751
11
Nathan Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.1.8]
b. 2 Apr 1759 d. 28 Jul 1810
Rachel Campbell
b. 1760 d. Aft 1822
12
Nancy Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.1.8.1]
b. Abt 1782
12
Charissa Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.1.8.2]
b. 1788 d. 1859 [
=>
]
12
Isaac Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.1.8.3]
b. 3 Mar 1786 d. 5 Dec 1825 [
=>
]
12
Sarah Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.1.8.4]
b. Abt 1788
12
Sybil Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.1.8.5]
b. 1790 d. 1810
12
Nathan Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.1.8.6]
b. Abt 1792
12
Rachel Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.1.8.7]
b. Abt 1794
11
Ezra Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.1.9]
b. 13 Jan 1761
Ruba Ann Herrick
b. 23 Jun 1792 d. 12 Apr 1873
12
Ezra Whipple, Jr
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.1.9.1]
b. 26 Oct 1813 d. 22 Aug 1895 [
=>
]
12
Robert Bishop Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.1.9.2]
b. 16 Oct 1815 d. 1895 [
=>
]
12
Ruba Ann "Ruby" Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.1.9.3]
b. 16 Oct 1815 d. 8 Nov 1854 [
=>
]
12
Eliza Diana Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.1.9.4]
b. 16 Dec 1817 d. 13 Dec 1894 [
=>
]
12
John Adams Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.1.9.5]
b. 8 Dec 1821 d. 2 Apr 1897
12
Happy Caroline Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.1.9.6]
b. 17 Aug 1824 d. 15 Jul 1860 [
=>
]
12
Lucy Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.1.9.7]
b. 22 Mar 1826 d. 31 May 1859 [
=>
]
12
Charles H Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.1.9.8]
b. 14 Mar 1830 d. 24 Feb 1899
12
Hibbird W Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.1.9.9]
b. 13 Apr 1833 d. 3 Jun 1866
11
Isaac Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.1.10]
b. 14 Apr 1764
10
Timothy Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2]
b. 28 Oct 1723 d. 4 Nov 1796
Elizabeth Safford
b. 4 Sep 1724 d. 10 Feb 1810
11
Ruth Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.1]
b. 1 Jul 1745 d. 1803
Lieutenant William Brace
b. 1750 d. 1820
12
Hiram Lyman Brace
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.1.1]
b. 19 Mar 1798 d. 30 Jan 1882 [
=>
]
12
Harvey Brace
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.1.2]
b. 14 Jul 1801 d. 24 Aug 1875 [
=>
]
11
Mercy Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.2]
b. 15 Mar 1747 d. 23 Dec 1843
William Riley McCraney
b. 21 Aug 1750 d. 1823
12
Ruth Cranney
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.2.1]
b. 1771
12
Hannah Cranney
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.2.2]
b. 1773
12
William Cranney
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.2.3]
b. 10 Nov 1775 d. 30 Jan 1854 [
=>
]
12
John Cranney
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.2.4]
b. 1777 [
=>
]
12
Desire Cranney
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.2.5]
b. 1779 [
=>
]
12
Mercy Cranney
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.2.6]
b. 1781 d. 10 Feb 1805
12
Gad Cranney
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.2.7]
b. 1784 [
=>
]
12
Clarissa Cranney
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.2.8]
b. 3 Aug 1788 d. 26 Jun 1814 [
=>
]
11
Dorothy Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.3]
b. 19 Apr 1750 d. 17 May 1830
Noah Bennett
b. 4 Jul 1746 d. 25 Nov 1833
12
Derastus Bennett
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.3.1]
b. 6 Sep 1770 d. 10 Mar 1859
12
Safford Bennett
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.3.2]
b. 29 Jul 1772 d. 1774
12
Safford Bennett
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.3.3]
b. 28 May 1774 d. 7 Apr 1860 [
=>
]
12
Elizabeth Bennett
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.3.4]
b. 26 May 1776
12
Nancy Bennett
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.3.5]
b. Feb 1779
12
Dolly Bennett
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.3.6]
b. 29 Aug 1781 d. 18 Nov 1853
12
Noah Bennett
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.3.7]
b. 6 Jul 1784 d. 3 Oct 1842
12
Cynthia Bennett
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.3.8]
b. 8 May 1786 d. 30 Apr 1873 [
=>
]
12
Almena Bennett
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.3.9]
b. 19 Jun 1788 d. 6 Feb 1875 [
=>
]
11
Elizabeth Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.4]
b. 1 Jan 1753 d. 31 Dec 1829
Jonathan Welles
b. 7 Mar 1753 d. 5 Jan 1778
12
Emeline Wells
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.4.1]
b. 1775 d. 13 Mar 1813 [
=>
]
Lieutenant Reuben Church
b. 21 Mar 1757 d. 18 Sep 1839
12
Reuben Church
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.4.2]
b. 6 Dec 1782 d. 23 Sep 1821 [
=>
]
12
Elizabeth Letitia Church
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.4.3]
b. 22 Mar 1784 d. 21 Feb 1835 [
=>
]
12
Jonathan Wells Church
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.4.4]
b. 2 Apr 1786 d. 10 Jun 1833 [
=>
]
12
Mary Church
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.4.5]
b. 6 Feb 1791 d. 25 Jan 1823
12
Alonzo Christy Church
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.4.6]
b. 9 Apr 1793 d. 18 May 1862 [
=>
]
12
Abigail Church
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.4.7]
b. Abt 1799
12
Elvira Church
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.4.8]
b. Abt 1801 d. Bef 21 Sep 1833
12
Rebecca Church
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.4.9]
b. Abt 1803
11
Eleanor Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.5]
b. 10 Apr 1756 d. 28 Aug 1826
Simeon Nash
b. 15 May 1756 d. 20 Feb 1813
12
Timothy Nash
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.5.1]
b. 8 Sep 1779 d. 16 Sep 1779
12
Chester Nash
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.5.2]
b. 8 Oct 1780
12
Guy Nash
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.5.3]
b. Abt 1783 d. 19 Aug 1825 [
=>
]
12
Louisa Nash
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.5.4]
b. 13 Mar 1788 d. 1850 [
=>
]
12
Simeon Nash, Jr
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.5.5]
b. 9 Dec 1790
12
Jared Nash
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.5.6]
b. 14 Jul 1793 d. 14 Feb 1831 [
=>
]
12
Eleanor Nash
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.5.7]
b. 18 Aug 1796 d. 1849
12
Alfred Nash
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.5.8]
b. 5 Jul 1800 d. Aft 1888 [
=>
]
11
Zipporah Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.6]
b. 17 Mar 1757 d. 12 Mar 1810
Joseph Bennett
b. 2 May 1731 d. 23 Apr 1837
12
Ralph Bennett
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.6.1]
b. 1778
12
Alfred Bennett
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.6.2]
b. 1780 d. 10 Mar 1861
12
Varney Bennett
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.6.3]
b. 1782
12
Zeporah Bennett
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.6.4]
b. 1783
12
Joseph Bennett
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.6.5]
b. 11 Sep 1788 [
=>
]
12
Thankful Bennett
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.6.6]
b. 1791
12
William Bennett
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.6.7]
b. 1795 d. 23 Jun 1863 [
=>
]
12
Polly Bennett
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.6.8]
b. 1797
12
Adin Bennett
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.6.9]
b. 1800 d. 6 May 1830 [
=>
]
11
William Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.7]
b. 17 Feb 1763 d. 30 Oct 1848
Sophia Prouty
b. 5 Jun 1768 d. 22 Nov 1837
12
Dimmis Prouty Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.7.1]
b. 18 Oct 1792 d. 22 Apr 1871 [
=>
]
12
William Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.7.2]
b. 17 Jan 1793 d. 25 Dec 1860 [
=>
]
12
Sophia Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.7.3]
b. 5 Oct 1794 d. 4 Jul 1868 [
=>
]
12
Elizabeth "Betsy" Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.7.4]
b. 9 Sep 1796
12
Lydia Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.7.5]
b. 2 Jun 1798
12
Timothy Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.7.6]
b. 19 Jan 1800 d. 1864 [
=>
]
12
Elijah Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.7.7]
b. 9 Apr 1801
11
John Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.8]
b. 7 Feb 1765 d. 7 Nov 1830
Basmoth Hutchins
b. 7 Sep 1769 d. 9 Sep 1846
12
Betsy Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.8.1]
b. 25 Feb 1790 d. 7 Nov 1822
12
John Whipple, Jr
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.8.2]
b. 11 Feb 1791 d. 2 Mar 1872 [
=>
]
12
Dimmis Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.8.3]
b. 26 Dec 1792 d. 2 Mar 1864 [
=>
]
12
Polly Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.8.4]
b. 23 Dec 1794 d. 18 Oct 1876 [
=>
]
12
Samuel Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.8.5]
b. 2 Oct 1796 d. 8 Jun 1867 [
=>
]
12
Alfred Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.8.6]
b. 14 Sep 1798 d. 2 Jun 1872 [
=>
]
12
Laura Ann Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.8.7]
b. 29 Apr 1803 d. 12 Mar 1860 [
=>
]
12
Edson Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.8.8]
b. 5 Feb 1805 d. 11 May 1894 [
=>
]
12
Elvira Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.8.9]
b. 10 Mar 1807 d. 14 Nov 1881 [
=>
]
12
Maria Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.8.10]
b. 27 May 1809 d. 27 Dec 1816
12
Emeline Safford Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.8.11]
b. 20 Mar 1814 d. 22 Feb 1868 [
=>
]
11
Dimmis Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.2.9]
b. 5 Jul 1768 d. 1841
+
Blakely Safford
b. Abt 1759 d. Abt 1839
10
Joseph Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.3]
b. 1725 d. 1805
10
Daniel Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.3.4]
b. Abt 1727
+
Zipporah Bolles
b. 11 Oct 1711 d. 1779
9
Daniel Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.4]
b. 11 Oct 1698 d. 16 Apr 1789
Hannah Hough
b. 28 Dec 1718 d. 3 Oct 1768
10
Elizabeth Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.1]
b. 15 Feb 1746
10
Anna Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.2]
b. 15 Feb 1746 d. 26 Sep 1830
William Rogers
b. 5 Aug 1746 d. 2 Apr 1835
11
William Rogers
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.2.1]
b. 5 Jun 1770 d. 22 May 1851
Mary Hoyt
b. 25 Jul 1776 d. 21 Mar 1844
12
William Rogers
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.2.1.1]
b. 15 Jun 1795 d. 29 Aug 1796
12
James Rogers
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.2.1.2]
b. 14 Jun 1797 d. 1800
12
Eliza Rogers
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.2.1.3]
b. 12 Nov 1799 d. 13 Jun 1843
12
James Hervey Rogers
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.2.1.4]
b. 1801 d. 1842
12
William Eastman Rogers
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.2.1.5]
b. 12 Feb 1805 d. 11 Sep 1862 [
=>
]
12
Benjamin Franklin Rogers
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.2.1.6]
b. 7 Feb 1807 d. 18 May 1841 [
=>
]
12
Jason Rogers
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.2.1.7]
b. 11 Apr 1809 d. 18 Aug 1860 [
=>
]
11
Ann Rogers
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.2.2]
b. 5 Feb 1773 d. 12 Jul 1789
11
Mary Rogers
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.2.3]
b. 1 Sep 1774 d. 22 Mar 1779
11
Elisabeth Rogers
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.2.4]
b. 16 Apr 1776 d. 5 Jan 1779
11
Ichabod Rogers
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.2.5]
b. 24 Apr 1777 d. 18 Apr 1778
11
Lucy Rogers
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.2.6]
b. 7 Jul 1778 d. 9 Apr 1779
11
Hannah Rogers
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.2.7]
b. 7 Jul 1778 d. 24 Sep 1778
11
Daniel Rogers
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.2.8]
b. 17 Feb 1780 d. 12 Jul 1839
Rebecca Conklin
b. 24 Feb 1792 d. 4 Dec 1847
12
Mary Ann Rogers
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.2.8.1]
b. 28 Apr 1825 d. 5 Oct 1897
12
Helen Rogers
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.2.8.2]
b. 25 Apr 1828 d. 7 Aug 1874 [
=>
]
11
Mary Rogers
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.2.9]
b. 31 Dec 1781 d. 30 Nov 1782
11
David Rogers
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.2.10]
b. 11 Feb 1783 d. 1849
Amy Ann Allan
b. 1786
12
Leander Rogers
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.2.10.1]
b. 12 Nov 1808 d. 30 Oct 1849 [
=>
]
12
Jeremiah Rogers
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.2.10.2]
b. 19 Jan 1811
12
Emma Rogers
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.2.10.3]
b. 17 May 1814 d. 30 Jun 1898 [
=>
]
12
George Rogers
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.2.10.4]
b. 8 Jul 1819
12
Nathan Griswald Rogers
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.2.10.5]
b. 21 Oct 1821 d. 2 Feb 1849 [
=>
]
12
Anna Rogers
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.2.10.6]
b. 28 Dec 1821 d. 28 May 1826
12
Elizabeth Rogers
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.2.10.7]
b. 17 Apr 1824 d. 24 May 1847
12
David Rogers
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.2.10.8]
b. 5 Sep 1826 d. 22 Dec 1848
11
Ichabod Rogers
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.2.11]
b. 10 Dec 1784 d. 4 Nov 1860
Eliza Cooper
b. 1785 d. 14 Aug 1862
12
Ann Eliza Rogers
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.2.11.1]
b. 9 Sep 1812 d. 5 Apr 1891 [
=>
]
12
Ferdinand Rogers
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.2.11.2]
b. Abt 1815 d. 17 Jan 1876 [
=>
]
12
Edgar Rogers
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.2.11.3]
b. 8 Oct 1819
12
Robert Cooper Rogers
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.2.11.4]
b. Abt 1822 d. 20 Jun 1888 [
=>
]
11
Mehitable Rogers
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.2.12]
b. 4 Oct 1788
Charles Gilbert Irish
b. 20 Jan 1791 d. 12 Jul 1869
12
Benjamin Gardner Irish
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.2.12.1]
b. 31 Mar 1814 d. 15 Mar 1875 [
=>
]
12
Harriet Ann Irish
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.2.12.2]
b. 14 Dec 1815 d. 10 Dec 1817
12
Charles Gilbert Irish
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.2.12.3]
b. 14 May 1817 d. 22 Jan 1901 [
=>
]
12
Caroline Matilda Irish
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.2.12.4]
b. 8 Feb 1819 [
=>
]
12
William Norman Irish
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.2.12.5]
b. 19 Mar 1821 d. 2 Dec 1896 [
=>
]
12
Sarah Irish
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.2.12.6]
b. 30 Mar 1823
12
Lydia Gardner Irish
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.2.12.7]
b. 17 Aug 1827 d. 29 Jul 1849 [
=>
]
12
Mary Budd Irish
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.2.12.8]
b. 17 Nov 1829
12
Maria Louise Irish
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.2.12.9]
b. 15 Nov 1843
11
Jememiah Rogers
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.2.13]
b. 4 Jul 1789
Sarah Vosburg
b. Abt 1793
12
Mary Rogers
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.2.13.1]
b. Abt 1816
12
Sarah Rogers
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.2.13.2]
b. Abt 1818 [
=>
]
12
Charles Rogers
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.2.13.3]
b. Abt 1820
12
Jeremiah Rogers
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.2.13.4]
b. Abt 1822
12
Edgar Rogers
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.2.13.5]
b. Abt 1824
12
Amelia Rogers
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.2.13.6]
b. Abt 1826
10
Lucretia Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.3]
b. 15 Jan 1748
10
Jeremiah Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.4]
b. 1 Mar 1751 d. 1830
10
Phebe Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.5]
b. 11 Mar 1753
Joseph Fuller
b. 19 Feb 1744
11
Lucy Fuller
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.5.1]
b. 29 Oct 1769 d. 1 Aug 1823
John Tuthill
b. 30 Jun 1766 d. 25 Sep 1836
12
John Tuthill
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.5.1.1]
b. 7 Aug 1792
12
Tyrus Tuthill
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.5.1.2]
b. 30 Mar 1794 d. 2 Dec 1891 [
=>
]
12
Martha Tuthill
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.5.1.3]
b. 5 Apr 1800 d. 15 Aug 1879 [
=>
]
12
Sanford Tuthill
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.5.1.4]
b. 11 Sep 1802 d. 22 Mar 1883 [
=>
]
12
Cynthia Tuthill
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.5.1.5]
b. 30 Sep 1804 d. 2 Nov 1859 [
=>
]
12
Harriet Melvina Tuthill
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.5.1.6]
b. 18 Feb 1814 d. 8 Jun 1859
11
Joseph Fuller, Jr
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.5.2]
b. Abt 1771 d. Aft 1835
11
William Fuller
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.5.3]
b. 1775 d. Aft 1820
11
Johnathan Fuller
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.5.4]
b. Bef 1784
11
Mary Fuller
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.5.5]
b. 5 Jul 1784 d. 1865
Levi Lawrence
b. 15 Jun 1784 d. 1832
12
Eliza Hunt Lawrence
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.5.5.1]
b. 1808 d. 1866
12
Mary Ann Lawrence
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.5.5.2]
b. 17 Aug 1809 d. 1847 [
=>
]
11
Levi Fuller
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.5.6]
b. Abt 1791 d. Aft 1870
Charlotte Barrows
b. 30 Dec 1786
12
William Fuller
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.5.6.1]
b. Abt 1814
12
Clarissa Fuller
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.5.6.2]
b. Abt 1815
12
Willard Fuller
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.5.6.3]
+
Rebekah Bugbey
+
Mary Riblet
b. 1791
11
Sarah Fuller
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.5.7]
b. 22 Feb 1792 d. 27 May 1829
Ruben Haley
b. 15 May 1786 d. 17 Aug 1820
12
Cynthia Ann Haley
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.5.7.1]
b. 24 Oct 1813 d. 9 Feb 1899 [
=>
]
12
Thomas Jefferson Haley
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.5.7.2]
b. 14 Oct 1817 d. 19 Jul 1898
12
Ruben Haley
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.5.7.3]
b. 1819 d. 5 Oct 1847
Dennison Stearns
b. 4 Jan 1792 d. 23 Jan 1875
12
Joseph Denison Stearns
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.5.7.4]
b. 26 Nov 1827 d. 23 Jan 1903 [
=>
]
12
Reuben Stearns
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.5.7.5]
b. 23 Nov 1829
12
George Stearns
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.5.7.6]
b. 1850
10
Ebenezer Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.6]
b. 4 Jun 1755 d. 2 Nov 1826
10
Priscilla Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.4.7]
b. 4 Feb 1757 d. 1852
9
Hope Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.5]
b. 12 Aug 1701 d. Bef 28 Oct 1739
Walter Capron
b. 2 Oct 1693 d. Abt 1770
10
Samuel Capron
[1.5.1.1.4.1.3.2.5.1]
b. 30 Sep 1722 d. 20 Mar 1745
10
Elkanah Capron
[1.5.1.1.4.1.3.2.5.2]
b. 15 Oct 1723 d. Bef 1740
10
Elizabeth Capron
[1.5.1.1.4.1.3.2.5.3]
b. 7 Apr 1725 d. 2 Apr 1810
10
Alice Capron
[1.5.1.1.4.1.3.2.5.4]
b. 24 Feb 1727
10
Sybil Capron
[1.5.1.1.4.1.3.2.5.5]
b. 30 Apr 1730
10
Sylvia Capron
[1.5.1.1.4.1.3.2.5.6]
b. 1734 d. 29 Nov 1759
10
William Capron
[1.5.1.1.4.1.3.2.5.7]
b. 17 Aug 1736 d. 1796
9
Nathan Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.6]
b. 5 Apr 1704 d. 1 Apr 1725
9
Zachariah Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.7]
b. 2 Feb 1707 d. 1760
Elizabeth Rogers
b. 14 Jun 1706 d. 18 Sep 1751
10
Elizabeth Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.1]
b. 15 Mar 1728
10
Bathasheba Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.2]
b. 6 Jun 1731 d. 1806
John Turner
b. 1725 d. 1817
11
John Turner
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.2.1]
b. 16 Nov 1751 d. 14 Sep 1814
11
Elizabeth Turner
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.2.2]
b. 15 Jan 1753
11
Eleanor Turner
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.2.3]
b. 1755
11
James turner
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.2.4]
b. 1757
11
Samuel Turner
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.2.5]
b. 30 Oct 1761 d. Bef 1817
11
Matthew Turner
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.2.6]
b. 11 Apr 1764
11
Thomas Turner
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.2.7]
b. 1765 d. 1838
11
Bathsheba Turner
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.2.8]
b. 11 Nov 1769 d. 8 May 1856
10
Zepaniah Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.3]
b. 3 Feb 1733
10
Alice Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.4]
b. 11 Dec 1734
10
John Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.5]
b. 14 Feb 1738 d. 24 Sep 1753
10
Hope Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.6]
b. 7 Feb 1740 d. 28 Mar 1829
Noah Whipple
b. 10 Jan 1742 d. Abt 17 Jun 1774
11
Eunice Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.6.1]
b. 16 Jun 1764
Comfort Chapman
b. 1760 d. 1786
12
Samuel Chapman
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.6.1.1]
b. 1778 d. 1805 [
=>
]
12
Betsy Chapman
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.6.1.2]
b. 1787
Epharim Hawley
b. 1762 d. 24 Aug 1850
12
Noah Whaley
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.6.1.3]
b. 1794
11
Samuel Stillman Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.6.2]
b. 28 Jun 1766 d. 23 Mar 1843
Hephzibah Gates
b. 24 Dec 1765 d. 3 Nov 1822
12
Hephzibah Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.6.2.1]
b. 18 Jun 1790 d. 6 Oct 1849 [
=>
]
12
Noah Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.6.2.2]
b. 6 Apr 1792 d. 26 Oct 1871 [
=>
]
12
Jonathan Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.6.2.3]
b. 14 Aug 1794 d. 11 Feb 1875 [
=>
]
12
Jabez Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.6.2.4]
b. 15 Apr 1796 d. 14 Dec 1870 [
=>
]
12
Samuel Stillman Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.6.2.5]
b. 30 Mar 1798 d. 5 Jun 1836 [
=>
]
12
Elizabeth Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.6.2.6]
b. 19 Apr 1800 d. 20 Nov 1882 [
=>
]
11
Jonathan Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.6.3]
b. 14 Aug 1769 d. Jan 1795
Hannah Stark
b. 1771 d. 30 Sep 1827
12
Daniel Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.6.3.1]
b. 22 Jun 1794 d. 8 Feb 1835 [
=>
]
11
Noah Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.6.4]
b. 9 Aug 1771
+
Peggy Dunbar
b. 1775
11
Silas Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.6.5]
b. 25 Jul 1773 d. 1835
Ester Watrous
b. 1772 d. 1853
12
Esther Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.6.5.1]
b. 16 Apr 1795 d. 4 Oct 1847 [
=>
]
12
Hope Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.6.5.2]
b. 1797 [
=>
]
12
Content Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.6.5.3]
b. 18 Jun 1798 d. 23 Jun 1820
12
Ellis Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.6.5.4]
b. 1800 d. 1820
12
Hannah Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.6.5.5]
b. 1802 d. 10 Jul 1825 [
=>
]
12
Eunice Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.6.5.6]
b. 14 Feb 1805 d. 7 Nov 1829 [
=>
]
12
Thankful Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.6.5.7]
b. 24 Sep 1806 d. 26 May 1894 [
=>
]
12
Silas Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.6.5.8]
b. Abt 1807
12
Abigail Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.6.5.9]
b. Apr 1810 d. Dec 1810
12
Timothy Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.6.5.10]
b. Feb 1811 d. Apr 1811
12
Alice Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.6.5.11]
b. 1814 d. 12 Feb 1891 [
=>
]
Sergeant Robert Gowdy
b. Abt 1737
11
Jane Gowdy
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.6.6]
b. 24 Sep 1779 d. 1861
Amos Watrous
b. 4 Dec 1774 d. 20 Mar 1801
12
Rebecca Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.6.6.1]
b. 10 Dec 1798 d. 29 Jul 1875 [
=>
]
12
Amos Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.6.6.2]
b. 5 Aug 1800 d. 20 Aug 1820
Benajah Davis
b. 1785 d. 1849
12
Laura Ann Davis
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.6.6.3]
b. 1810 d. 11 Oct 1875
12
Jane Davis
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.6.6.4]
b. 1812
12
Lucy F Davis
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.6.6.5]
b. 25 Jul 1815
12
Mary Davis
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.6.6.6]
b. 1817 d. 1872
12
Benajah Davis
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.6.6.7]
b. 7 Apr 1820 d. 12 Dec 1904
12
Jeptha Davis
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.6.6.8]
b. 26 Oct 1822 d. 5 Feb 1867
11
Mary "Polly" Gowdy
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.6.7]
b. 5 Dec 1782 d. 4 Mar 1871
Jabesh or Jabes Watrous
b. 2 Mar 1774 d. 31 May 1820
12
Mary "Polly" Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.6.7.1]
b. 12 Jan 1799 d. 3 Jun 1820 [
=>
]
12
Hopewell G Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.6.7.2]
b. 4 Mar 1800 d. 5 Oct 1866
12
Fanny Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.6.7.3]
b. 4 Feb 1801 d. 3 Jun 1820
12
Jabez Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.6.7.4]
b. 23 Nov 1803 d. 24 Dec 1900 [
=>
]
12
Jane Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.6.7.5]
b. 15 Sep 1805 d. 25 Apr 1838
12
Robert Gowdy Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.6.7.6]
b. 13 Sep 1807 d. 2 Feb 1895
12
Bathsheba Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.6.7.7]
b. 11 Nov 1809 d. 24 Jul 1895
12
Ezra Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.6.7.8]
b. 9 Jan 1811 d. 27 Mar 1865
12
Ira Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.6.7.9]
b. 2 Mar 1814 d. 22 Mar 1888
12
Cyrus Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.6.7.10]
b. 13 Aug 1816 d. 25 May 1820
12
Elias Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.6.7.11]
b. 8 Mar 1819 d. 25 Sep 1889
10
Content Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7]
b. 27 Mar 1743 d. Abt 1830
Timothy Waterhouse
b. 19 Jun 1740 d. 5 Sep 1814
11
Timothy Whipple Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.1]
b. 26 May 1765 d. 26 Apr 1820
Hannah Wilcox
b. 25 May 1766 d. 6 Apr 1851
12
William Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.1.1]
b. Abt 1786 d. 21 Oct 1834 [
=>
]
12
Daniel Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.1.2]
b. 20 Feb 1793 d. 18 Apr 1879 [
=>
]
12
Timothy Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.1.3]
b. Abt 1787 d. 5 Sep 1814
12
Henry Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.1.4]
b. 14 Oct 1791 d. 26 Jan 1872 [
=>
]
12
Hannah Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.1.5]
b. 7 Apr 1795
12
Mary Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.1.6]
b. 16 Jan 1797
12
Sarah "Sally" Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.1.7]
b. 16 Nov 1798 d. 13 Sep 1838 [
=>
]
12
Joseph Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.1.8]
b. 29 Sep 1800 d. 1 Dec 1875 [
=>
]
12
Silas Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.1.9]
b. 20 Aug 1802 d. 23 Nov 1852 [
=>
]
12
James Allen Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.1.10]
b. 7 Jun 1804 d. 28 Dec 1884
12
Hannah Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.1.11]
b. 26 Mar 1805
12
Nathan Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.1.12]
b. 19 Jan 1808 d. 1820
12
Content Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.1.13]
b. 11 Dec 1809
11
Zachariah Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.2]
b. 1767 d. 1807
Sarah Adams
b. Abt 1767
12
Zachariah Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.2.1]
b. Abt 1793
12
Lydia Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.2.2]
b. Abt 1796 d. 12 Jan 1870 [
=>
]
12
Content Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.2.3]
b. Abt 1802
12
Sally Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.2.4]
b. Abt 1802
11
Content Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.3]
b. 1769 d. 1853
William Crouch
b. 1766 d. Oct 1840
12
William Crouch
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.3.1]
b. 1792
12
Content Crouch
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.3.2]
b. 5 Oct 1794 d. 30 Apr 1835 [
=>
]
12
Timothy Crouch
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.3.3]
b. 1797
12
Mary Crouch
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.3.4]
b. 30 Apr 1801 d. 11 Sep 1884 [
=>
]
12
David Crouch
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.3.5]
b. 7 Jun 1806 d. 25 May 1891 [
=>
]
12
Jabez Crouch
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.3.6]
b. 7 Oct 1807 d. 7 Jul 1887 [
=>
]
12
Zachariah Crouch
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.3.7]
b. 8 Oct 1809 d. 27 Dec 1888 [
=>
]
12
Hannah Crouch
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.3.8]
b. 1811 d. 1835 [
=>
]
12
Esther Crouch
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.3.9]
b. 18 May 1812 d. 27 Oct 1888
12
Christian "Christina" Crouch
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.3.10]
b. 23 Oct 1799 d. 5 Jul 1884 [
=>
]
11
Ester Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.4]
b. 1772 d. 1853
Silas Whipple
b. 25 Jul 1773 d. 1835
12
Esther Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.4.1]
b. 16 Apr 1795 d. 4 Oct 1847 [
=>
]
12
Hope Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.4.2]
b. 1797 [
=>
]
12
Content Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.4.3]
b. 18 Jun 1798 d. 23 Jun 1820
12
Ellis Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.4.4]
b. 1800 d. 1820
12
Hannah Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.4.5]
b. 1802 d. 10 Jul 1825 [
=>
]
12
Eunice Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.4.6]
b. 14 Feb 1805 d. 7 Nov 1829 [
=>
]
12
Thankful Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.4.7]
b. 24 Sep 1806 d. 26 May 1894 [
=>
]
12
Silas Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.4.8]
b. Abt 1807
12
Abigail Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.4.9]
b. Apr 1810 d. Dec 1810
12
Timothy Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.4.10]
b. Feb 1811 d. Apr 1811
12
Alice Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.4.11]
b. 1814 d. 12 Feb 1891 [
=>
]
11
Jabesh or Jabes Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.5]
b. 2 Mar 1774 d. 31 May 1820
Mary "Polly" Gowdy
b. 5 Dec 1782 d. 4 Mar 1871
12
Mary "Polly" Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.5.1]
b. 12 Jan 1799 d. 3 Jun 1820 [
=>
]
12
Hopewell G Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.5.2]
b. 4 Mar 1800 d. 5 Oct 1866
12
Fanny Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.5.3]
b. 4 Feb 1801 d. 3 Jun 1820
12
Jabez Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.5.4]
b. 23 Nov 1803 d. 24 Dec 1900 [
=>
]
12
Jane Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.5.5]
b. 15 Sep 1805 d. 25 Apr 1838
12
Robert Gowdy Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.5.6]
b. 13 Sep 1807 d. 2 Feb 1895
12
Bathsheba Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.5.7]
b. 11 Nov 1809 d. 24 Jul 1895
12
Ezra Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.5.8]
b. 9 Jan 1811 d. 27 Mar 1865
12
Ira Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.5.9]
b. 2 Mar 1814 d. 22 Mar 1888
12
Cyrus Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.5.10]
b. 13 Aug 1816 d. 25 May 1820
12
Elias Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.5.11]
b. 8 Mar 1819 d. 25 Sep 1889
11
Zephaniah Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.6]
b. 1 May 1776 d. Dec 1780
11
John Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.7]
b. 10 Feb 1778 d. 11 Jun 1820
Desire Rogers
b. 20 Jul 1780 d. 12 Mar 1821
12
Desire Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.7.1]
b. Abt 1804 d. 3 Jun 1820
12
Alexander Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.7.2]
b. 1804 d. 1836 [
=>
]
12
Rachel Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.7.3]
b. 9 May 1806 d. 7 Mar 1826 [
=>
]
12
Joseph Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.7.4]
b. 1806
12
John Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.7.5]
b. 1810
12
Abel Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.7.6]
b. 1812
12
David Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.7.7]
b. 12 Apr 1812 d. 17 Feb 1850
12
Asaph Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.7.8]
b. 1814 d. 31 Jan 1892
12
Content Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.7.9]
b. 1816 d. 27 Apr 1844
11
Elizabeth Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.8]
b. 5 Apr 1780 d. Aft 1862
John Crouch
b. 1777 d. 1869
12
Elizabeth Crouch
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.8.1]
b. 26 Jun 1796 d. 26 Nov 1883 [
=>
]
12
John Crouch, Jr
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.8.2]
b. 19 May 1800 d. Mar 1868 [
=>
]
12
Mary Crouch
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.8.3]
b. 1802 d. 12 Jan 1891
12
Abiah Crouch
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.8.4]
b. 18 Sep 1804 d. 21 Nov 1871 [
=>
]
12
Annie Crouch
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.8.5]
b. Abt 1805 [
=>
]
12
Joel Crouch
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.8.6]
b. Abt 1806 [
=>
]
12
Solomon Crouch
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.8.7]
b. Abt 1809
12
Daniel Crouch
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.8.8]
b. Abt 1814
12
Christian Crouch
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.8.9]
b. 1824 [
=>
]
11
Abiah Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.9]
b. 1 May 1782 d. 1820
Samuel Chapman
b. Abt 1781 d. 20 Apr 1868
12
Samuel Chapman
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.9.1]
b. 30 Jan 1806 d. 16 Oct 1844 [
=>
]
12
Nathan Chapman
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.9.2]
b. 27 Mar 1807 d. 28 Nov 1885 [
=>
]
12
Abiah Chapman
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.9.3]
b. 18 Oct 1808 d. 8 May 1899 [
=>
]
12
Timothy Chapman
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.9.4]
b. Mar 1810
12
Benjamin Franklin Chapman
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.9.5]
b. 13 Oct 1811 d. 29 Dec 1901 [
=>
]
12
Ori Chapman
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.9.6]
b. 18 Sep 1813 d. 1898 [
=>
]
11
Zephaniah Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.10]
b. 23 Apr 1785 d. 1858
Sarah Rogers
b. 26 Apr 1783
12
Zephaniah Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.10.1]
b. 30 Oct 1806 d. 10 Jun 1868 [
=>
]
12
Sarah Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.10.2]
b. 22 May 1808
12
Esther Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.10.3]
b. 29 Nov 1809 d. Apr 1903 [
=>
]
12
Mary Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.10.4]
b. 17 Jun 1811 d. 1845 [
=>
]
12
Reuben Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.10.5]
b. 17 Dec 1812
12
Amy Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.10.6]
b. 3 Jul 1815
12
Phebe Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.10.7]
b. 13 Jun 1818
12
Stephen Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.10.8]
b. 16 Nov 1820
12
Timothy Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.10.9]
b. Abt 1822
12
Rachel Watrous
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.7.10.10]
b. Abt 1824
10
Zachariah Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.7.8]
b. 6 Jun 1745
9
Zephaniah Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.8]
b. 1709 d. 1760
Kesiah Parke
b. Abt 1700 d. Aft 4 Apr 1769
10
Solomon Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.8.1]
b. 26 Jul 1743 d. Bef 4 Apr 1769
10
Zephaniah Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.8.2]
b. Abt 1746 d. Bef 1800
10
Elijah Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.8.3]
b. Abt 1748 d. Aft 1826
10
Isaiah Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.8.4]
b. Abt 1750
9
Elizabeth Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.2.9]
b. Feb 1718 d. Nov 1718
8
Thomas Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3]
b. Abt 1671 d. 31 Mar 1766
Abigail Jenckes
b. 1676 d. 12 Mar 1756
9
Mary Harris Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.1]
b. Abt 1697
9
Thomas Whipple, Jr
[1.5.1.1.4.1.3.3.2]
b. Abt 1698 d. 20 Nov 1771
Mary Gary
b. 20 Jul 1699 d. 21 Feb 1767
10
Thomas Whipple, III
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.1]
b. 16 Jul 1723
Abigail Wood
11
Noah Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.1.1]
b. 23 Apr 1747
11
Ann Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.1.2]
b. 17 Jan 1749
11
Noah Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.1.3]
b. 3 May 1753
10
Mary Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.2]
b. 23 Jul 1725 d. Nov 1763
Moses Pelton
b. 1728 d. 16 Apr 1778
11
Hannah Pelton
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.2.1]
b. 3 Jan 1749 d. 10 May 1754
11
Moses Pelton, Jr
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.2.2]
b. 27 Jun 1751 d. 19 Jun 1809
11
Joel Pelton
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.2.3]
b. 5 Nov 1752 d. 7 Mar 1856
11
Mary Pelton
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.2.4]
b. 26 Feb 1754
11
Hannah Pelton
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.2.5]
b. 30 Aug 1755 d. 16 Feb 1817
11
Lemuel Pelton
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.2.6]
b. 1757
11
Elizabeth Pelton
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.2.7]
b. Nov 1763
10
Abigail Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.3]
b. 8 Jun 1727 d. 14 Jan 1728
10
Abraham Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.4]
b. 16 Feb 1728 d. 11 Mar 1729
10
Abigail Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.5]
b. 30 Jan 1729 d. 21 Apr 1806
Elijah Miner
b. Abt 1732 d. 18 Aug 1756
11
Abigail Miner
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.5.1]
b. 24 Dec 1756
11
Christiana Miner
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.5.2]
b. 29 Dec 1751 d. 24 Jun 1808
Thomas Davis
12
Elijah Davis
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.5.2.1]
b. 30 Jun 1775 d. 26 Feb 1834
12
Thomas Davis
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.5.2.2]
b. 13 Nov 1777
12
Sarah Davis
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.5.2.3]
b. 25 Apr 1780 d. 20 Aug 1848
12
Levina Davis
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.5.2.4]
b. 18 Apr 1782
12
Roswell Davis
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.5.2.5]
b. 18 Feb 1785 d. 14 May 1848
12
Polly Davis
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.5.2.6]
b. 31 Jul 1791 d. 28 Apr 1794
Jonathan Dickinson
b. 18 Nov 1738 d. 16 Oct 1762
11
Mary Dickinson
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.5.3]
b. 25 Dec 1758 d. 5 Mar 1759
11
Jonathan Dickinson
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.5.4]
b. 30 Sep 1760
11
Mary Dickinson
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.5.5]
b. Mar 1762 d. May 1850
Isaac Buck
b. 1739 d. 6 Feb 1825
11
Elijah Buck
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.5.6]
b. 11 Apr 1760 d. 24 Aug 1852
+
Submit Willson
b. 1765
11
Isaac Buck, Jr
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.5.7]
b. 11 Sep 1762
11
Susannah Buck
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.5.8]
b. 16 Dec 1764
11
William Buck
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.5.9]
b. 3 Nov 1766
11
Sarah Buck
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.5.10]
b. 22 Apr 1769 d. 1858
Samuel Parsons
b. 1767
12
Clarissa Parsons
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.5.10.1]
b. 21 Mar 1791 d. 23 Jan 1849 [
=>
]
12
Parmelia Parsons
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.5.10.2]
b. 12 Oct 1793
12
Harvey Parsons
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.5.10.3]
b. 3 Sep 1795 d. 28 Mar 1861
12
Samuel Parsons
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.5.10.4]
b. 19 Nov 1797
12
Elijah Parsons
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.5.10.5]
b. 1800
12
Lyman Parsons
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.5.10.6]
b. 10 Jun 1801 d. 5 Nov 1883
12
Sally Parsons
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.5.10.7]
b. 26 Jun 1803
12
Amity Parsons
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.5.10.8]
b. 1806 d. 23 Oct 1806
12
Orrin Parsons
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.5.10.9]
b. 3 Jul 1807
12
Elam Parsons
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.5.10.10]
b. 2 Aug 1809 d. 1893
12
Lucina Parsons
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.5.10.11]
b. 1811 d. 11 Nov 1879
12
Lura Amity Parsons
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.5.10.12]
b. 20 Aug 1813
11
Elenor Buck
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.5.11]
b. 15 Jun 1771
11
Lavina Buck
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.5.12]
b. 11 Dec 1773
10
Nathan Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.6]
b. 24 Dec 1731 d. 19 Mar 1813
Hannah White
b. 22 Aug 1729
11
Hannah Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.6.1]
b. 15 Apr 1758
11
Atener Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.6.2]
b. 4 Apr 1763
11
Thomas Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.6.3]
b. 23 Oct 1760
11
Nathan Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.6.4]
b. 30 Mar 1766 d. 1 Jul 1832
11
Susannah Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.6.5]
b. 18 Jan 1754
11
Patience Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.6.6]
b. 19 Jan 1756
10
Rachel Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.7]
b. 13 Oct 1733
Captain Nathaniel Hamlin
b. 7 Jan 1739 d. 27 Dec 1818
11
Charity Hamblin
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.7.1]
b. 30 Jan 1755
11
Levi Hamblin
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.7.2]
b. 11 Jun 1757
11
John Hamlin
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.7.3]
b. 12 Mar 1761 d. 30 Oct 1825
11
William Hamblin
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.7.4]
b. 17 May 1763
11
Asrariah Hamblin
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.7.5]
b. 27 Mar 1765
10
Ann Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.8]
b. 21 Oct 1735
Isaac Wyborn
b. 1727 d. Aft 1802
11
Prudence Wyborn
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.8.1]
b. 1762
11
William Gershon Wyborn
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.8.2]
b. 24 Jan 1777 d. 22 Mar 1857
11
Lucy Wyborn
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.8.3]
b. 1778
11
John M Wyborn
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.8.4]
b. Abt 1779
11
Bevil Granville Wyborn
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.8.5]
b. 15 Oct 1783 d. 9 May 1872
11
Daughter Wyborn
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.8.6]
b. Abt 1789
10
Elizabeth Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.9]
b. 26 Feb 1739
10
Amos Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.2.10]
b. 22 Jan 1742
9
Enoch Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.3]
b. Abt 1703 d. 18 Jan 1725
9
Abraham Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4]
b. Abt 1709 d. 3 Oct 1768
Mary Jones
b. 22 Apr 1709 d. 4 Nov 1780
10
Bathsheba Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.1]
b. 2 Feb 1731
10
Abraham Whipple, Jr
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.2]
b. 18 Mar 1734
10
Mary Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.3]
b. 1 Mar 1735 d. 6 Dec 1823
10
Samuel Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.4]
b. 7 Jan 1737 d. 28 Sep 1762
+
Oliver Evans
b. Abt 1741
10
Joseph Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.5]
b. 18 May 1740
Abigail Gary
b. 2 Jul 1743
11
Abraham Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.5.1]
b. 11 Feb 1768 d. 12 Jan 1852
10
Luther Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.6]
b. 7 Mar 1743 d. 1830
Eunice Gates
b. Abt 1744
11
Abram Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.6.1]
b. 11 Feb 1768 d. 12 Jan 1852
Asenath Sumner
b. 2 Aug 1768 d. 23 Dec 1851
12
Abigail Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.6.1.1]
b. 1794 d. 13 Apr 1870 [
=>
]
12
Louisa Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.6.1.2]
b. 1798 d. 12 Apr 1889
12
Eunice Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.6.1.3]
b. 1800
12
Daniel Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.6.1.4]
b. 20 Nov 1801 d. 26 Apr 1889 [
=>
]
12
Asenath "Sena" Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.6.1.5]
b. 1803 d. 27 May 1896 [
=>
]
12
Lydia Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.6.1.6]
b. 1806 d. 19 Sep 1880 [
=>
]
12
Henry Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.6.1.7]
b. 22 May 1807 d. 13 Jan 1895 [
=>
]
12
George "Leo" Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.6.1.8]
b. 18 May 1809 d. 19 Jul 1896 [
=>
]
12
Abraham Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.6.1.9]
b. 1810 d. Abt 1888 [
=>
]
12
Caroline Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.6.1.10]
b. 1811
12
Jane Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.6.1.11]
b. 1812 d. 3 Aug 1872
11
Eunice Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.6.2]
b. 18 Mar 1770 d. 26 Feb 1863
11
Polly Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.6.3]
b. 1772 d. 24 Aug 1847
Thomas Whittlesey
b. 28 Feb 1772 d. 2 Mar 1847
12
Lucy Whittlesey
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.6.3.1]
b. Jun 1797 d. Jul 1865
12
Maria Whittlesey
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.6.3.2]
b. 9 Apr 1805
12
Eliza Whittlesey
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.6.3.3]
b. 19 Aug 1807 d. Abt 1831 [
=>
]
12
Thomas Jefferson Whittlesey
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.6.3.4]
b. 13 Jun 1812
12
Isaac Whittlesey
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.6.3.5]
b. 25 Mar 1815 [
=>
]
12
Francis Elmira Whittlesey
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.6.3.6]
b. 30 Sep 1817
11
Elizabeth Gates Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.6.4]
b. 19 Aug 1775 d. 26 Jun 1862
John Sawyer
b. 10 May 1773 d. 21 Apr 1871
12
Abraham Sawyer
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.6.4.1]
b. 1 Feb 1796 d. 9 Apr 1868
12
John Sawyer
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.6.4.2]
b. 14 Apr 1805 d. 26 Feb 1880 [
=>
]
12
Issac Sawyer
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.6.4.3]
b. 3 Sep 1816 d. 1 Jul 1912
12
Ira Sawyer
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.6.4.4]
b. 3 Sep 1816 d. 28 Nov 1899 [
=>
]
11
Lydia Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.6.5]
b. 1777
11
Martha Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.6.6]
b. 1781
11
Clarissa Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.6.7]
b. 11 Mar 1784
Joel Sawyer, Jr
b. 7 Aug 1781 d. 1 Sep 1859
12
Joel W Sawyer
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.6.7.1]
b. 6 Dec 1815 d. 25 Dec 1908
11
Henry Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.6.8]
b. Abt 1785 d. Aft 1800
11
Thomas Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.6.9]
b. 1787 d. 18 Sep 1887
Cynthia Allen
b. 3 Feb 1788 d. 30 Oct 1861
12
Allen G Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.6.9.1]
b. 1812 d. Aft 8 Jun 1880 [
=>
]
12
Thomas Corbin Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.6.9.2]
b. 28 Mar 1814 d. 9 Feb 1892 [
=>
]
12
Ruth Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.6.9.3]
b. Abt 1816
12
Abigail Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.6.9.4]
b. Abt 1818
12
Ira Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.6.9.5]
b. 2 Jan 1820 d. 7 Oct 1895
10
Anna Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7]
b. 17 Feb 1744 d. 1811
Robert Follett
b. 27 Apr 1739 d. 9 Apr 1810
11
Robert Follett
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7.1]
b. 15 Sep 1764
Molly Knap
b. 17 Apr 1766
12
Nancy Follett
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7.1.1]
b. Aft 1800
11
Anna Follett
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7.2]
b. 22 Mar 1766 d. 23 Apr 1839
Joseph Ford
b. 29 Feb 1768 d. 30 Jan 1846
12
Sarah Ford
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7.2.1]
b. 1793 d. 1842 [
=>
]
12
John Perley Ford
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7.2.2]
b. 6 Dec 1794 d. 18 Sep 1869 [
=>
]
12
Anna Ford
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7.2.3]
b. 1796
12
Mary Ophria Ford
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7.2.4]
b. 1798
12
Joseph Ford
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7.2.5]
b. 12 May 1800 d. 26 Sep 1882 [
=>
]
12
Chloe Ford
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7.2.6]
b. 1803 [
=>
]
11
Mary Follett
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7.3]
b. 10 Oct 1767 d. Bef 1810
11
Abigail Follett
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7.4]
b. 18 Feb 1770
John Delong
b. Abt 1768
12
Eunice Delong
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7.4.1]
b. 2 Dec 1796 d. 20 Feb 1884
11
Calvin Follett
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7.5]
b. 6 Jan 1772 d. 21 Dec 1856
Drusilla Kempton
b. Abt 1787 d. 8 Apr 1856
12
William Follett
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7.5.1]
b. 18 Dec 1801
12
Benjamin Follett
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7.5.2]
b. 22 Oct 1803 d. 11 Dec 1892 [
=>
]
12
Ephraim Follett
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7.5.3]
b. 24 Dec 1805 d. 1 May 1864 [
=>
]
12
Calvin Follett
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7.5.4]
b. 1807 [
=>
]
12
Anna Follett
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7.5.5]
b. 1809 d. 24 Aug 1832
12
Daughter Follett
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7.5.6]
b. 1810
12
Daughter Follett
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7.5.7]
b. 1813
12
Hiram Follett
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7.5.8]
b. 1 Nov 1816 d. 20 Jan 1892 [
=>
]
12
Louisa Follett
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7.5.9]
b. 1819
12
Calvin Follett
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7.5.10]
b. 1822
12
Mary Jane Follett
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7.5.11]
b. 1825 [
=>
]
12
Fanny Follett
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7.5.12]
b. 1831 d. 11 Mar 1832
11
Elijah Follett
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7.6]
b. 29 Mar 1775 d. Jul 1816
Sabra Hill
b. 28 Apr 1779 d. 24 Apr 1842
12
John Follett
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7.6.1]
b. Abt 1799
12
Sarah "Sally" Follett
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7.6.2]
b. Abt 1803 [
=>
]
12
Samuel Follett
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7.6.3]
b. 26 Dec 1803 d. 1885 [
=>
]
12
Orpha Follett
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7.6.4]
b. Abt 1805
12
Daniel Edward Follett
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7.6.5]
b. 11 Nov 1807 d. 27 Nov 1901 [
=>
]
12
Eunice Follett
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7.6.6]
b. Abt 1809
12
Ann Follett
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7.6.7]
b. Abt 1811
12
Elsie Follett
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7.6.8]
b. 1811
12
Joseph Follett
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7.6.9]
b. 17 Jun 1814 d. 1897 [
=>
]
11
Samuel Follett
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7.7]
b. 2 Apr 1776
Rebecca
b. Abt 1778
12
Permelia Follett
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7.7.1]
b. Abt 1817
11
William Follett
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7.8]
b. 3 Mar 1778 d. 1853
Sybil Blackman
b. 1780 d. Bef 1850
12
Betsy Follett
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7.8.1]
b. 1808
12
Ann Follett
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7.8.2]
b. 1810
12
John Follett
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7.8.3]
b. 1813 [
=>
]
12
William Follett
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7.8.4]
b. 1820 [
=>
]
12
Hannah Follett
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7.8.5]
b. 21 Feb 1824 d. 21 Oct 1898
12
Samuel B Follett
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7.8.6]
b. 6 Nov 1827 d. 13 Feb 1920 [
=>
]
12
Henry Follett
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7.8.7]
b. 15 Oct 1829 d. 31 May 1905
11
Eunice Follett
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7.9]
b. 28 Mar 1779
Joseph Baker
b. Abt 1777
12
Joseph Baker, Jr
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7.9.1]
b. Abt 1799
12
John Baker
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7.9.2]
b. Abt 1801
12
Erastus Baker
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7.9.3]
b. Abt 1803
12
Norma Baker
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7.9.4]
b. Abt 1805
12
Maria Baker
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7.9.5]
b. 1809 [
=>
]
11
John Follett
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.7.10]
b. 22 Aug 1783
+
Lydia Reed
b. 1785
10
Calvin Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.8]
b. 17 Aug 1745 d. 10 Nov 1762
10
Deborah Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.9]
b. 6 Aug 1747
10
Daniel Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.10]
b. 7 Sep 1749 d. 1798
Deborah Hildreth
b. 5 May 1755 d. Abt 1789
11
Samuel Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.10.1]
b. 1777 d. Aft 1800
11
Daniel Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.10.2]
b. 27 Aug 1779 d. 27 Sep 1839
Mary Tiffany
b. 17 Jun 1777 d. 12 Sep 1845
12
Cynthia Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.10.2.1]
b. 15 Jan 1805 d. 1889 [
=>
]
12
Samuel Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.10.2.2]
b. 21 Dec 1808 d. 9 Jan 1887 [
=>
]
12
Almira Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.10.2.3]
b. 13 Jun 1810 d. 4 Feb 1889 [
=>
]
12
Phoebe Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.10.2.4]
b. 13 Aug 1813 d. 18 Nov 1846 [
=>
]
12
Carum Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.10.2.5]
b. 12 Aug 1815 d. 1843
12
Gerua Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.10.2.6]
b. 12 Aug 1815 d. 18 Sep 1848
12
Nelson Wheeler Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.10.2.7]
b. 11 Jul 1818 d. 5 Jul 1887 [
=>
]
11
Richard Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.10.3]
b. Abt 1781 d. 25 May 1862
11
Roswell Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.10.4]
b. 1783 d. 25 May 1862
Melinda Gates
b. 26 May 1802 d. Abt 1827
12
Abram Gates Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.10.4.1]
b. 19 Oct 1826 d. 1913 [
=>
]
Hannah Weeks
b. 14 Oct 1806 d. 7 Apr 1889
12
William Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.10.4.2]
b. Mar 1834 d. Aft Jun 1900
12
Sarah Ann Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.10.4.3]
b. Abt 16 Feb 1834 d. 18 Jan 1919
12
Clarissa Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.10.4.4]
b. Feb 1838 d. 30 Jul 1921
12
Ella Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.10.4.5]
b. Abt 1839
12
Jane Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.10.4.6]
b. 1843
12
Emoline Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.10.4.7]
b. Abt 1848 d. 31 Mar 1923
12
Caroline Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.10.4.8]
b. Abt 1848
12
Frank E Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.10.4.9]
b. May 1857 d. Aft 1904
11
Polly Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.10.5]
b. Abt 1785
11
Lucy Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.10.6]
b. Abt 1787
+
Bingham
b. 1783
11
Cynthia Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.10.7]
b. 1789 d. 15 Feb 1856
Ebenezer Root
b. 17 Dec 1760 d. 12 Feb 1842
12
Jerusha Root
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.10.7.1]
b. 22 Feb 1804 d. 8 Jul 1889 [
=>
]
12
Charlotte Root
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.10.7.2]
b. 5 Jul 1805 d. 26 Oct 1900 [
=>
]
12
Polly Root
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.10.7.3]
b. 16 Apr 1807 d. 9 Dec 1853
12
Daniel W Root
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.10.7.4]
b. 29 May 1809 d. 23 Oct 1846
12
Harriet Root
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.10.7.5]
b. 27 Aug 1811 d. 26 Oct 1901
12
Alanson Root
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.10.7.6]
b. 19 Nov 1814 d. 1817
12
Cyras Root
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.10.7.7]
b. 10 Feb 1817
12
Silas Root
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.10.7.8]
b. 10 Feb 1817 d. 1 Apr 1904
10
Thomas Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.11]
b. 16 Mar 1751 d. 1833
Lydia Gates
b. Abt 1761 d. 17 Mar 1795
11
Lydia Gates Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.11.1]
b. 24 Jul 1779 d. 1 Sep 1864
Jonathan Carver Ames
b. 18 Mar 1774 d. 26 Apr 1853
12
Alvin Ames
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.11.1.1]
b. 8 Mar 1800 d. 11 Jun 1870 [
=>
]
12
Chester Ames
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.11.1.2]
b. 9 May 1801 d. 28 Aug 1891 [
=>
]
12
Joseph Ames
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.11.1.3]
b. 28 Sep 1802 d. 11 Apr 1851 [
=>
]
12
Mary Ames
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.11.1.4]
b. 3 Feb 1804 d. 23 Nov 1884
12
Johnathan Carver Ames
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.11.1.5]
b. 18 Apr 1807 d. 26 Mar 1868 [
=>
]
12
Thomas Whipple Ames
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.11.1.6]
b. 7 Apr 1808 d. 18 Jan 1885
12
Walter Whipple Ames
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.11.1.7]
b. 21 Jun 1810 d. 26 Apr 1887 [
=>
]
12
Caroline Ames
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.11.1.8]
b. 1 Apr 1811 d. 17 Apr 1828
12
Valeria Ames
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.11.1.9]
b. 24 Jun 1813 d. 15 Sep 1856
12
Levi Ames
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.11.1.10]
b. 11 Jun 1816 d. 31 Jul 1909
12
Phoebe Tabor Ames
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.11.1.11]
b. 18 Jun 1818 [
=>
]
12
Lydia Whipple Ames
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.11.1.12]
b. 15 Nov 1820 d. 25 Feb 1903 [
=>
]
11
Thomas Jefferson Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.11.2]
b. 1787 d. 23 Jan 1835
Phebe Taber
b. Aug 1784 d. 17 Aug 1823
12
Alonzo A Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.11.2.1]
b. 27 Feb 1811 d. 11 Mar 1887 [
=>
]
12
Thomas Jefferson Whipple, Jr
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.11.2.2]
b. 30 Jan 1816 d. 21 Dec 1889 [
=>
]
12
Caroline B Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.11.2.3]
b. 1 Apr 1820 d. 5 Oct 1910 [
=>
]
11
Mattie Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.11.3]
b. 8 May 1789 d. 4 Sep 1877
Paul Tabor
b. 12 Aug 1788 d. 3 Sep 1878
12
Mialma Tabor
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.11.3.1]
b. 8 Jan 1814 d. 26 Aug 1894 [
=>
]
12
Ann Tabor
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.11.3.2]
b. 5 Jul 1828 d. 29 Nov 1904 [
=>
]
11
Son Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.11.4]
b. Bef 1790 d. Aft 1790
11
Walter Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.11.5]
b. 28 Feb 1792 d. 24 Dec 1882
Susan A Donaldson
b. Abt 1795
12
Lothario Danielson Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.11.5.1]
b. 14 Sep 1831 d. 18 Nov 1847
Ruth Baker
b. Abt 1806 d. Aft 1880
12
Susan Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.11.5.2]
b. 1846
12
James Henry Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.4.11.5.3]
b. Dec 1857 [
=>
]
9
Patience Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.5]
b. Abt 1709
+
John Olney
b. Abt 1707
9
Noah Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.6]
b. Abt 1711
9
Nathan Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.3.7]
b. Abt 1713
8
Abigail Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.4]
b. 1683 d. 18 Sep 1735
Robert Currie
b. Abt 1680 d. Abt 1745
9
Samuel Currie
[1.5.1.1.4.1.3.4.1]
b. 4 Oct 1719 d. 31 Dec 1770
9
John Currie
[1.5.1.1.4.1.3.4.2]
b. 3 Jun 1721
9
James Currie
[1.5.1.1.4.1.3.4.3]
b. 3 Dec 1722
8
Hope Whipple
[1.5.1.1.4.1.3.5]
b. Abt 1685 d. 14 Feb 1716
+
Robert Currie
b. Abt 1680 d. Abt 1745
7
Thomas Harris
[1.5.1.1.4.1.4]
b. 1641 d. 27 Feb 1711
Elnathan Tew
b. 15 Oct 1644 d. 11 Jan 1718
8
Thomas Harris
[1.5.1.1.4.1.4.1]
b. 19 Oct 1665 d. 1 Sep 1741
8
Richard Harris
[1.5.1.1.4.1.4.2]
b. 14 Oct 1668 d. 18 Aug 1750
Elizabeth Lydia King
b. 1670 d. 28 Mar 1736
9
Amity Harris
[1.5.1.1.4.1.4.2.1]
b. 10 Oct 1697 d. 5 May 1749
9
Uriah Harris
[1.5.1.1.4.1.4.2.2]
b. 1700 d. 14 Apr 1729
9
Amaziah Harris
[1.5.1.1.4.1.4.2.3]
b. 13 Apr 1705 d. Aft 6 Mar 1738
9
Richard Harris
[1.5.1.1.4.1.4.2.4]
b. 4 Oct 1708 d. May 1784
9
Jonathan Harris
[1.5.1.1.4.1.4.2.5]
b. 12 Jul 1710 d. 24 Sep 1785
Mary Whipple Brown
b. 8 Apr 1709 d. 1 Dec 1740
10
Abner Harris
[1.5.1.1.4.1.4.2.5.1]
b. 10 Jun 1730 d. 16 Mar 1768
10
Jabez Harris
[1.5.1.1.4.1.4.2.5.2]
b. 1732 d. 1776
10
Mary Harris
[1.5.1.1.4.1.4.2.5.3]
b. 1734 d. 11 Jan 1785
10
Dinah Harris
[1.5.1.1.4.1.4.2.5.4]
b. 21 Oct 1737 d. 1821
9
David Harris
[1.5.1.1.4.1.4.2.6]
b. 7 Jan 1714 d. 31 Mar 1797
9
Preserved Harris
[1.5.1.1.4.1.4.2.7]
b. 15 Jun 1715 d. 4 May 1797
Martha Mowry
b. 1 Apr 1726 d. Apr 1774
10
Urania Harris
[1.5.1.1.4.1.4.2.7.1]
b. 2 Apr 1745 d. Bef 1794
10
Israel Harris
[1.5.1.1.4.1.4.2.7.2]
b. 14 Mar 1747 d. 5 Jul 1811
10
Rufus Harris
[1.5.1.1.4.1.4.2.7.3]
b. 23 Nov 1749 d. 30 May 1798
10
Lydia Harris
[1.5.1.1.4.1.4.2.7.4]
b. 8 May 1752 d. 8 Dec 1795
Nathaniel Spaulding
b. 15 Jul 1751 d. 10 Jun 1838
11
Amey Spaulding
[1.5.1.1.4.1.4.2.7.4.1]
b. 16 Feb 1775
10
Elnathan Harris
[1.5.1.1.4.1.4.2.7.5]
b. 21 Aug 1755 d. 22 Dec 1823
Oliver Arnold
b. 12 Apr 1752 d. 18 Jan 1790
11
Isaac Arnold
[1.5.1.1.4.1.4.2.7.5.1]
b. 11 Aug 1779 d. 12 Nov 1861
11
Oliver Arnold
[1.5.1.1.4.1.4.2.7.5.2]
b. 11 Apr 1781 d. 18 Apr 1785
11
Martin Arnold
[1.5.1.1.4.1.4.2.7.5.3]
b. 11 Nov 1783 d. 28 Oct 1847
+
Mary Spaulding
b. 16 Mar 1801 d. 29 Jul 1863
11
Sabera Arnold
[1.5.1.1.4.1.4.2.7.5.4]
b. 25 Jan 1786 d. 25 Nov 1873
11
Preserved Arnold
[1.5.1.1.4.1.4.2.7.5.5]
b. 10 Jun 1788 d. 10 Jul 1828
10
Nathan Harris
[1.5.1.1.4.1.4.2.7.6]
b. 23 Mar 1758 d. 11 Nov 1835
10
Jesse Harris
[1.5.1.1.4.1.4.2.7.7]
b. 6 Aug 1760 d. 8 Jun 1803
10
Martin Harris
[1.5.1.1.4.1.4.2.7.8]
b. 24 Feb 1764 d. 6 May 1797
10
Nathaniel Harris
[1.5.1.1.4.1.4.2.7.9]
b. 9 Jan 1774
8
Nicholas Harris
[1.5.1.1.4.1.4.3]
b. 15 Apr 1671 d. 27 Mar 1746
8
William Harris
[1.5.1.1.4.1.4.4]
b. 11 May 1673 d. 14 Jan 1726
8
Henry Harris
[1.5.1.1.4.1.4.5]
b. 10 Nov 1675 d. 29 Mar 1727
Lydia Olney
b. 26 Jan 1688 d. 1727
9
Thomas Harris
[1.5.1.1.4.1.4.5.1]
b. 1697 d. 23 Apr 1736
9
Henry Harris
[1.5.1.1.4.1.4.5.2]
b. 1699 d. 4 Mar 1738
9
Epenetus Harris
[1.5.1.1.4.1.4.5.3]
b. 21 Sep 1713
9
Lydia Harris
[1.5.1.1.4.1.4.5.4]
b. 1714 d. 1737
9
Elizabeth Harris
[1.5.1.1.4.1.4.5.5]
b. 11 Feb 1715
9
Elnathan Harris
[1.5.1.1.4.1.4.5.6]
b. 2 Dec 1717
9
Mary Harris
[1.5.1.1.4.1.4.5.7]
b. 9 Mar 1722
8
Amity Harris
[1.5.1.1.4.1.4.6]
b. 10 Dec 1677 d. 5 Jun 1749
8
Mary Harris
[1.5.1.1.4.1.4.7]
b. 1682 bur. 13 Sep 1765
7
Martha Harris
[1.5.1.1.4.1.5]
b. Abt 1643 d. 10 Aug 1717
Thomas Field
b. 28 May 1648 d. 10 Aug 1717
8
Amos Field
[1.5.1.1.4.1.5.1]
b. Abt 1677 d. Abt 1680
8
Elizabeth Field
[1.5.1.1.4.1.5.2]
b. 27 Aug 1670 d. 24 Jan 1709
8
William Field
[1.5.1.1.4.1.5.3]
b. 8 Jun 1682 d. 5 Nov 1729
8
Mary Field
[1.5.1.1.4.1.5.4]
b. 1 Jan 1671 d. Jun 1727
John Dexter
b. 1673 d. 22 Apr 1734
9
Naomi Dexter
[1.5.1.1.4.1.5.4.1]
b. 1698 d. 12 Dec 1777
Thomas Whipple
b. 26 Feb 1693 d. 13 Oct 1770
10
Abigail Whipple
[1.5.1.1.4.1.5.4.1.1]
b. 18 Jul 1721
10
Margery Whipple
[1.5.1.1.4.1.5.4.1.2]
b. 9 Sep 1722
10
Thomas Whipple
[1.5.1.1.4.1.5.4.1.3]
b. 8 Jul 1725 d. 4 Dec 1777
Anna Harris
b. 22 Apr 1732 d. 15 Jul 1789
11
Nicholas Whipple
[1.5.1.1.4.1.5.4.1.3.1]
b. 1751
11
Christopher Whipple
[1.5.1.1.4.1.5.4.1.3.2]
b. 1754 d. 1787
Sarah Cushing
b. 21 Apr 1782
12
Abigail Eliza Whipple
[1.5.1.1.4.1.5.4.1.3.2.1]
b. 21 Sep 1786 d. 6 Feb 1873 [
=>
]
11
George Whipple
[1.5.1.1.4.1.5.4.1.3.3]
b. 1760 d. 1 Aug 1848
11
Thomas Whipple
[1.5.1.1.4.1.5.4.1.3.4]
b. 17 Sep 1766 d. 7 Sep 1843
11
Amy Whipple
[1.5.1.1.4.1.5.4.1.3.5]
b. 1770
10
Siboleth or Sybil Whipple
[1.5.1.1.4.1.5.4.1.4]
b. 23 Oct 1726 d. 1 Oct 1793
10
Naomi Whipple
[1.5.1.1.4.1.5.4.1.5]
b. 28 Oct 1728
10
Anne Whipple
[1.5.1.1.4.1.5.4.1.6]
b. 14 Nov 1730
10
Levi Whipple
[1.5.1.1.4.1.5.4.1.7]
b. 4 Sep 1734
10
Voshty Whipple
[1.5.1.1.4.1.5.4.1.8]
b. 18 Nov 1736
10
Zilpah Whipple
[1.5.1.1.4.1.5.4.1.9]
b. 30 Oct 1737 d. 3 Sep 1767
9
Mary Dexter
[1.5.1.1.4.1.5.4.2]
b. 1699
Noah Whipple, Jr
b. 18 Dec 1697 d. 29 Feb 1784
10
Freelove Whipple
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.1]
b. 1736
Benjamin Pitts
b. 6 Nov 1754
11
James Pitts
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.1.1]
b. 5 Dec 1780
11
Marcy Whipple Pitts
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.1.2]
b. 14 Dec 1783
10
Susannah Whipple
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.2]
b. Abt 1723 d. 1804
Elisha Angell
b. 13 Oct 1719 d. 14 Nov 1755
11
Enoch Angell
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.2.1]
b. 15 Oct 1742 d. 17 Feb 1832
Amey Randall
b. Abt May 1751 d. 17 Dec 1767
12
Randall Angell
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.2.1.1]
b. 30 Nov 1767 d. 5 Sep 1855 [
=>
]
Freelove Randall
b. 16 Jun 1749 d. 7 Feb 1778
12
Elisha Angell
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.2.1.2]
b. 21 May 1770 d. 25 Feb 1846 [
=>
]
12
Stephen Angell
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.2.1.3]
b. Abt 20 Mar 1776 d. 1 Feb 1818
12
Nathaniel Angel
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.2.1.4]
b. 12 Mar 1780 d. 3 Aug 1832 [
=>
]
11
Mary Angel
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.2.2]
b. 4 Oct 1744
Jonathan Comstock
b. 7 Sep 1737 d. 4 Dec 1784
12
Felix Comstock
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.2.2.1]
b. 1770 d. 22 Jul 1822
12
Thomas Comstock
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.2.2.2]
b. 7 May 1775 d. 7 Sep 1834
12
Ichabod Comstock
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.2.2.3]
b. 1776 bur. Jan 1775
12
Lucy Comstock
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.2.2.4]
b. 1778
11
Abner Angell
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.2.3]
b. 1746
+
Almyra Whitman
b. 1782
11
Martha Angell
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.2.4]
b. Abt 19 May 1750 d. 8 Jun 1790
David Soule
b. 1741
12
Thomas Soule
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.2.4.1]
b. 1784
12
Constant Soule
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.2.4.2]
b. 14 May 1785
12
Samuel Soule
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.2.4.3]
b. 1796
11
Isaac Angell
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.2.5]
b. 17 Jul 1753 d. 9 Dec 1831
Salley Williams
b. 1760
12
James Angell
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.2.5.1]
b. Abt 1781 d. 20 Nov 1870
12
Susanna Angell
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.2.5.2]
b. 12 May 1782 d. 22 May 1837
12
Robert Angell
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.2.5.3]
b. 15 Mar 1786 d. 14 Nov 1862
12
Anna Angell
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.2.5.4]
b. Dec 1788 d. 14 Apr 1832
12
Sarah Williams Angell
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.2.5.5]
b. Abt 12 Feb 1791 d. 20 Jul 1810
12
Elizabeth Williams Angell
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.2.5.6]
b. Abt 6 May 1793 d. 25 Oct 1810
James Angell
b. 31 May 1731 d. Jun 1806
11
Sally Angell
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.2.6]
b. 30 Oct 1757
10
Mary Whipple
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.3]
b. Abt 1729 d. 12 Sep 1805
10
Commodore Abraham Whipple
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.4]
b. 26 Sep 1732 d. 27 May 1819
Sarah Hopkins
b. 26 Sep 1739 d. 14 Oct 1818
11
Catherine Whipple
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.4.1]
b. Abt 1762 d. 1834
Ebenezer Sproat
b. 9 Feb 1752 d. 29 Aug 1819
12
Sarah Whipple Sproat
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.4.1.1]
b. 28 Jan 1782 d. 22 Jan 1851
11
Captain John Hopkins Whipple
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.4.2]
b. 2 Jul 1765
11
Mary Whipple
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.4.3]
b. Abt 1767 d. 15 Aug 1831
Ezekiel Comstock
b. 17 Jan 1762 d. Abt 27 Feb 1828
12
Elizabeth Carter Comstock
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.4.3.1]
b. 1792 d. 29 Sep 1822
12
Sarah Ann Comstock
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.4.3.2]
b. 21 Jan 1795 d. 29 Sep 1854
12
William Whipple Comstock
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.4.3.3]
b. 23 Mar 1801 d. 20 Oct 1878
10
Samuel Whipple
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.5]
b. Abt 1740 d. 6 Feb 1827
Elizabeth Snow
b. 28 Sep 1739 d. 22 Sep 1806
11
Noah Whipple
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.5.1]
b. 15 Feb 1772
11
Samuel Whipple, Jr
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.5.2]
b. 4 Jul 1774 d. 9 Nov 1843
Mary Chaffee
b. 1779 d. 12 Mar 1828
12
Lucy A Whipple
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.5.2.1]
b. 4 May 1800 d. 18 Apr 1887
12
John N Whipple
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.5.2.2]
b. 1801 d. 29 Dec 1865
12
Joseph H Whipple
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.5.2.3]
b. 3 May 1803 d. 1 Aug 1891
12
Sarepta Whipple
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.5.2.4]
b. 16 Aug 1808 d. 5 Nov 1840
12
Sabrina Whipple
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.5.2.5]
b. 1808 d. 1900
12
Reuben Chaffee Whipple
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.5.2.6]
b. 1809 d. 21 Jan 1828
12
Jonathan C Whipple
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.5.2.7]
b. 1811
12
Mary Ann Whipple
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.5.2.8]
b. 1814
12
Samuel A Whipple
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.5.2.9]
b. 1815 d. 1886
12
Gustavus A Whipple
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.5.2.10]
b. 1816
12
Elizabeth S Whipple
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.5.2.11]
b. 1822
12
Martha B Whipple
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.5.2.12]
b. 1823 d. 1894
11
Sarah Whipple
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.5.3]
b. 1776 d. 21 Jan 1824
Aaron Rice
b. 11 Nov 1768 d. 11 Jul 1822
12
Samuel Rice
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.5.3.1]
b. 20 Apr 1798 d. 10 Oct 1892
12
Harvey Rice
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.5.3.2]
b. 1800 d. 23 Sep 1848
12
Harriet Rice
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.5.3.3]
b. 13 Aug 1805 d. 31 Mar 1867
12
Roxanna Rice
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.5.3.4]
b. 1808
12
Sabrina Celestina Rice
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.5.3.5]
b. 1810 d. 1863
12
Sally Rice
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.5.3.6]
b. 1811
12
Willard Rice
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.5.3.7]
b. 1812
12
Sarah Rice
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.5.3.8]
b. 1814 d. 22 Apr 1833
12
Anna Rice
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.5.3.9]
b. 1816
11
Hopestill Whipple
[1.5.1.1.4.1.5.4.2.5.4]
b. 3 Oct 1778 d. 21 Mar 1860
9
John Dexter
[1.5.1.1.4.1.5.4.3]
b. 1701 d. 29 Aug 1780
Mary Brown
b. 30 Jul 1699 d. Aft 1730
10
Mary Dexter
[1.5.1.1.4.1.5.4.3.1]
b. 1725
10
Lydia Dexter
[1.5.1.1.4.1.5.4.3.2]
b. 18 Jul 1729 d. 21 Aug 1791
10
Jonathan Dexter
[1.5.1.1.4.1.5.4.3.3]
b. 4 Aug 1739 d. 31 Jul 1819
Alice Low
b. 1741 d. 1 Sep 1831
11
Mary Dexter
[1.5.1.1.4.1.5.4.3.3.1]
b. 1762
11
Philip Dexter
[1.5.1.1.4.1.5.4.3.3.2]
b. 1766
11
Joseph Dexter
[1.5.1.1.4.1.5.4.3.3.3]
b. 1764
11
Elizabeth Dexter
[1.5.1.1.4.1.5.4.3.3.4]
b. 1768
11
Christopher Dexter
[1.5.1.1.4.1.5.4.3.3.5]
b. 1770 d. Aft 1811
Betsey Whipple
b. 9 Jan 1768 d. Aft 1811
12
Anthony Dexter
[1.5.1.1.4.1.5.4.3.3.5.1]
b. 1791 [
=>
]
12
Susan Dexter
[1.5.1.1.4.1.5.4.3.3.5.2]
b. 1793
12
Amy Dexter
[1.5.1.1.4.1.5.4.3.3.5.3]
b. 1796
12
Mary Dexter
[1.5.1.1.4.1.5.4.3.3.5.4]
b. Abt 1799 d. 30 May 1937 [
=>
]
12
Betsey Dexter
[1.5.1.1.4.1.5.4.3.3.5.5]
b. 18 Mar 1803 [
=>
]
12
Maria Dexter
[1.5.1.1.4.1.5.4.3.3.5.6]
b. 1805
12
Christopher C Dexter
[1.5.1.1.4.1.5.4.3.3.5.7]
b. 1807
12
Caroline Dexter
[1.5.1.1.4.1.5.4.3.3.5.8]
b. Abt 1812 d. 6 Jun 1866 [
=>
]
11
Abigail Dexter
[1.5.1.1.4.1.5.4.3.3.6]
b. 1772
11
Sarah Dexter
[1.5.1.1.4.1.5.4.3.3.7]
b. 1776
11
Lydia Dexter
[1.5.1.1.4.1.5.4.3.3.8]
b. 1778 d. 10 May 1838
11
John Dexter
[1.5.1.1.4.1.5.4.3.3.9]
b. 29 Aug 1780 d. 27 Aug 1840
11
Anne Nancy Dexter
[1.5.1.1.4.1.5.4.3.3.10]
b. 1782
Captain Sterry Jenckes
b. 6 Feb 1787 d. 26 Nov 1853
12
Horatio Nelson Jenckes
[1.5.1.1.4.1.5.4.3.3.10.1]
b. 8 Aug 1810 d. 30 Dec 1828
12
Elcy Ann Jenckes
[1.5.1.1.4.1.5.4.3.3.10.2]
b. 3 Sep 1813 d. 12 Dec 1828
12
Jabez Walcott Jenckes
[1.5.1.1.4.1.5.4.3.3.10.3]
b. 7 Jan 1815 d. 11 Jan 1883
12
Rhoda Ann Jenckes
[1.5.1.1.4.1.5.4.3.3.10.4]
b. 15 Jan 1818 d. 7 Aug 1847 [
=>
]
12
Diana Jenckes
[1.5.1.1.4.1.5.4.3.3.10.5]
b. 7 Apr 1820 d. 4 Mar 1890
12
Albert Cheney Jenckes
[1.5.1.1.4.1.5.4.3.3.10.6]
b. 16 Mar 1822 d. 22 Dec 1887
12
Mary Humphry Jenckes
[1.5.1.1.4.1.5.4.3.3.10.7]
b. 24 Jan 1824 d. 17 Mar 1914
12
Charles Erastus Jenckes
[1.5.1.1.4.1.5.4.3.3.10.8]
b. 10 Oct 1825 d. 7 Apr 1896
12
Ardelia Jenckes
[1.5.1.1.4.1.5.4.3.3.10.9]
b. 9 Sep 1827 d. 8 Sep 1925
12
Henry Hartwell Jenckes
[1.5.1.1.4.1.5.4.3.3.10.10]
b. 14 Aug 1829
12
Nathaniel Miles Jenckes
[1.5.1.1.4.1.5.4.3.3.10.11]
b. 28 Aug 1831 d. 5 Jul 1892
12
George F Jenckes
[1.5.1.1.4.1.5.4.3.3.10.12]
b. 7 May 1834 d. 27 May 1922
11
Alice L Dexter
[1.5.1.1.4.1.5.4.3.3.11]
b. Abt 1768 d. 27 Sep 1863
9
Sarah Dexter
[1.5.1.1.4.1.5.4.4]
b. Apr 1703 d. 30 Oct 1779
Captain Solomon Smith
b. 4 Mar 1702 d. 25 Mar 1771
10
Ezekiel Smith
[1.5.1.1.4.1.5.4.4.1]
b. 13 Mar 1726 d. 18 Jul 1777
10
Mercy Smith
[1.5.1.1.4.1.5.4.4.2]
b. 12 Jan 1727 d. 4 Jan 1776
John Winsor
b. 2 Mar 1723 d. 30 Mar 1808
11
Stephen Winsor
[1.5.1.1.4.1.5.4.4.2.1]
b. 14 Dec 1744 d. 14 Jan 1820
11
Sarah Winsor
[1.5.1.1.4.1.5.4.4.2.2]
b. 4 Jun 1746 d. 1797
John Smith
b. 14 Feb 1740 d. 31 Mar 1798
12
Thankful Smith
[1.5.1.1.4.1.5.4.4.2.2.1]
b. 11 Jan 1763 d. Jul 1860
12
Cyna Smith
[1.5.1.1.4.1.5.4.4.2.2.2]
b. 7 Sep 1765 d. 11 Jan 1776
12
Mercy Smith
[1.5.1.1.4.1.5.4.4.2.2.3]
b. 30 Nov 1770 [
=>
]
12
Samuel Smith
[1.5.1.1.4.1.5.4.4.2.2.4]
b. Abt 1770 d. 14 Sep 1813
12
Eber Smith
[1.5.1.1.4.1.5.4.4.2.2.5]
b. 10 May 1773 d. 26 May 1844
12
Zenas Smith
[1.5.1.1.4.1.5.4.4.2.2.6]
b. 5 Jun 1775
12
Mary Smith
[1.5.1.1.4.1.5.4.4.2.2.7]
b. 30 Jul 1778 d. 6 May 1843
11
Providence Winsor
[1.5.1.1.4.1.5.4.4.2.3]
b. 3 Dec 1747 d. Aug 1778
11
Joshua Winsor
[1.5.1.1.4.1.5.4.4.2.4]
b. 19 Jan 1749 d. 19 Jan 1770
11
Ruth Winsor
[1.5.1.1.4.1.5.4.4.2.5]
b. 18 May 1751
11
Alice Winsor
[1.5.1.1.4.1.5.4.4.2.6]
b. 12 Jan 1753 d. 4 Jan 1785
11
Deborah Winsor
[1.5.1.1.4.1.5.4.4.2.7]
b. 31 Mar 1756 d. 3 Apr 1815
11
Candace Winsor
[1.5.1.1.4.1.5.4.4.2.8]
b. 1 Feb 1758 d. 1846
11
Thomas Winsor
[1.5.1.1.4.1.5.4.4.2.9]
b. 21 Oct 1759 d. 25 Feb 1798
11
Mercy Ann Winsor
[1.5.1.1.4.1.5.4.4.2.10]
b. 5 Aug 1761 d. 13 Sep 1813
11
Zilpha Winsor
[1.5.1.1.4.1.5.4.4.2.11]
b. 1 Apr 1763 d. 18 Jun 1773
11
Cynthia Winsor
[1.5.1.1.4.1.5.4.4.2.12]
b. 20 May 1765 d. 1847
11
Lydia Winsor
[1.5.1.1.4.1.5.4.4.2.13]
b. 1 Jan 1767 d. Aft 1806
10
Captain John S Smith
[1.5.1.1.4.1.5.4.4.3]
b. 20 Jan 1730 d. 7 May 1828
10
William Smith
[1.5.1.1.4.1.5.4.4.4]
b. 5 Mar 1732 d. 3 Jul 1736
10
Sarah Smith
[1.5.1.1.4.1.5.4.4.5]
b. 4 May 1734
10
Anphillis Smith
[1.5.1.1.4.1.5.4.4.6]
b. 4 Oct 1736
10
Ruth Smith
[1.5.1.1.4.1.5.4.4.7]
b. May 1739
10
Naomi Smith
[1.5.1.1.4.1.5.4.4.8]
b. 3 May 1741 d. Mar 1794
10
Mary Smith
[1.5.1.1.4.1.5.4.4.9]
b. 24 Dec 1742
10
Margaret Smith
[1.5.1.1.4.1.5.4.4.10]
b. 1744 d. Mar 1794
9
Stephen Dexter
[1.5.1.1.4.1.5.4.5]
b. 1703 d. 1 Oct 1741
9
Jeremiah Dexter
[1.5.1.1.4.1.5.4.6]
b. 1705
9
Lydia Dexter
[1.5.1.1.4.1.5.4.7]
b. 1709
9
William Dexter
[1.5.1.1.4.1.5.4.8]
b. 1711
9
Abigail Dexter
[1.5.1.1.4.1.5.4.9]
b. 1712 d. 13 Dec 1792
9
Jonathan Dexter
[1.5.1.1.4.1.5.4.10]
b. 1713
8
Thomas Field, Jr
[1.5.1.1.4.1.5.5]
b. 3 Jan 1670 d. 17 Jul 1752
Abigail Dexter
b. Abt 1675 d. Aft 19 Aug 1725
9
Thomas Field III
[1.5.1.1.4.1.5.5.1]
b. 1696 d. 20 May 1777
9
Joseph Field
[1.5.1.1.4.1.5.5.2]
b. 1699 d. 5 Oct 1736
9
Stephen Field
[1.5.1.1.4.1.5.5.3]
b. Abt 1700 d. 10 Sep 1727
9
Jeremiah Field
[1.5.1.1.4.1.5.5.4]
b. 1706 d. 2 Sep 1768
9
Nathaniel Field
[1.5.1.1.4.1.5.5.5]
b. 1708 d. 3 Jan 1753
9
Anthony Field
[1.5.1.1.4.1.5.5.6]
b. 1712 d. 19 Apr 1762
+
Abigail Chaffe
b. Abt 1689 d. Aft 1753
8
Martha Field
[1.5.1.1.4.1.5.6]
b. 1683 d. 1735
7
Margaret Harris
[1.5.1.1.4.1.6]
b. 1643 d. 2 Apr 1659
4
Jarvis Austin
[1.5.1.2]
b. 16 Jul 1554 d. 5 Jun 1610
4
Mykaell Austin
[1.5.1.3]
b. 4 Dec 1555 bur. 25 Dec 1555
4
Margareta Austin
[1.5.1.4]
b. 15 Mar 1557 d. 22 May 1566
4
Margery Austin
[1.5.1.5]
b. 26 Mar 1557 d. 13 Jan 1566
4
Michael Austin
[1.5.1.6]
c. 19 Feb 1559
3
Thomas Austin
[1.5.2]
b. Abt 1524 d. 12 Apr 1589
3
John Austin
[1.5.3]
b. 1525
3
Mary Austin
[1.5.4]
b. 1526 d. 1599
3
Thomas Henry Austin
[1.5.5]
b. 1527 d. 21 Feb 1571
3
Susan Austin
[1.5.6]
b. Abt 1528 d. 1599
3
Margarett Austin
[1.5.7]
b. Abt 1529 d. 30 Jul 1568
2
Nicholas Austin
[1.6]
b. Abt 1486
2
John Austin
[1.7]
b. 1492 d. 1576