Home Page
|
What's New
|
Photos
|
Histories
|
Headstones
|
Reports
|
Surnames
Search
First Name:
Last Name:
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Suomalainen
Svenska
Stephen Austin
1520 - 1558 (37 years)
Submit Photo / Document
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Submit Photo / Doc
Worksheet
Family
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Stephen Austin
[1]
b. 22 Apr 1520 d. 25 Feb 1558
Elizabeth Bassock
b. 1527 bur. 17 Mar 1563
2
Joanne Austin
[1.1]
b. 1 Jan 1553 d. 28 Oct 1586
Henry Harris
b. 1552 d. 20 Nov 1616
3
John Harris
[1.1.1]
b. 14 Jul 1580 d. 19 Jul 1609
3
Dorytye Harris
[1.1.2]
b. Abt 1582 d. 27 Apr 1589
3
Sara Harris
[1.1.3]
b. 26 Apr 1584
3
Andrew Harris
[1.1.4]
b. 6 Jun 1585 d. Bef 2 Nov 1616
Jane Bagley
b. Abt 1584 d. 11 Apr 1676
4
Thomas Harris
[1.1.4.1]
b. 12 Apr 1605 d. 7 Jun 1686
Elizabeth Cutter
b. 22 Apr 1608 d. 1 Sep 1687
5
William Harris
[1.1.4.1.1]
b. 1633
Edith Bligh
b. 1620 d. 5 Aug 1685
6
Martha Harris
[1.1.4.1.1.1]
b. Abt 1642 d. 14 Jul 1710
Joseph Coit
b. 1630 d. 27 Mar 1704
7
John Coit
[1.1.4.1.1.1.1]
b. 1 Dec 1670 d. 22 Oct 1744
7
Joseph Coit
[1.1.4.1.1.1.2]
b. 4 Apr 1673 d. 1 Jul 1750
Elisabeth Wheeler
b. 22 May 1683 bur. 14 Apr 1735
8
Colonel Samuel Coit
[1.1.4.1.1.1.2.1]
b. 1707 d. 4 Oct 1792
8
Joseph Coit
[1.1.4.1.1.1.2.2]
b. Abt 1711 d. 21 Jul 1741
8
Abigail Coit
[1.1.4.1.1.1.2.3]
b. 18 Apr 1712 d. 27 Aug 1799
Thomas Gates
b. 15 Jun 1709 d. 28 Nov 1784
9
Abigail Gates
[1.1.4.1.1.1.2.3.1]
b. 31 Dec 1735
Charles Spaulding
b. 12 Dec 1735 d. 15 Mar 1807
10
Dutee Spaulding
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.1]
b. 29 Nov 1765 d. 4 Dec 1840
10
Daniel L Spaulding
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.2]
b. 8 Aug 1767 d. 8 Aug 1817
10
Anna N Spaulding
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3]
b. 1770 d. 1825
Solomon Farnham Kimball
b. 1770 d. 1825
11
Charles Spaulding Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.1]
b. 1796 d. 16 Jan 1830
11
Eliza Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.2]
b. 1797 d. 1867
11
Heber Chase Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3]
b. 14 Jun 1801 d. 22 Jun 1868
Vilate Murray
b. 1 Jun 1806 d. 22 Oct 1867
12
Judith Marvin Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.1]
b. 29 Jul 1823 d. 20 May 1824
12
William Henry Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.2]
b. 10 Apr 1826 d. 30 Dec 1907
12
Helen Mar Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.3]
b. 25 Aug 1828 bur. 15 Nov 1896 [
=>
]
12
Roswell Heber Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.4]
b. 10 Jun 1831 d. 15 Jun 1831
12
Heber Parley Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.5]
b. 1 Jun 1835 d. 8 Feb 1885
12
David Patten Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.6]
b. 23 Aug 1839 d. 21 Nov 1883
12
Charles Spaulding Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.7]
b. 2 Jan 1843 d. 2 Dec 1925
12
Brigham Willard Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.8]
b. 29 Jan 1845 d. 23 Jul 1867
12
Solomon Farnham Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.9]
b. 2 Feb 1847 d. 7 Feb 1920
12
Murray Gould Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.10]
b. 20 Jan 1850 d. 27 Jun 1852
+
Ruth Wellington
b. 11 Mar 1809
Ann Alice Gheen
b. 20 Dec 1827 d. 12 Oct 1879
12
Samuel Heber Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.11]
b. 9 Dec 1851 d. 18 Apr 1943
12
Daniel Heber Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.12]
b. 8 Feb 1856 d. 26 Apr 1936
12
Alice Ann Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.13]
b. 6 Sep 1858 d. 19 Dec 1946 [
=>
]
12
Andrew Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.14]
b. 6 Sep 1858 d. 31 Aug 1924 [
=>
]
12
Sarah Gheen Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.15]
b. 31 May 1861 d. 8 Feb 1913
Mary Ellen Harris Abel
b. 5 Oct 1818 d. 28 Oct 1902
12
Peter Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.16]
b. 19 Dec 1855 d. 27 Sep 1860
+
Charlotte Chase
b. 11 May 1825 d. 15 Dec 1904
+
Nancy Maria Winchester
b. 10 Aug 1828 d. 17 Mar 1876
+
Sarah A Lawrence
b. 13 May 1826 d. 28 Nov 1872
Aagaat "Ellen Sanders" Ysteinsdatter
b. 11 Apr 1823 d. 22 Nov 1871
12
Samuel Chase Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.17]
b. 13 Feb 1848 d. 26 Jul 1848
12
Augusta Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.18]
b. 2 Jun 1850 d. 5 Oct 1861
12
Joseph Smith Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.19]
b. 2 Jun 1850 d. 20 Nov 1864
12
Rosalia Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.20]
b. 25 Nov 1853 d. 22 Feb 1950
12
Jedediah Heber Chase Grant Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.21]
b. 10 Mar 1855 d. 24 Jun 1927
Frances Jessie Swan
b. 21 Jun 1822 d. 30 May 1894
12
Margaret Jane Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.22]
b. 9 Apr 1846 d. 10 Aug 1846
Clarissa Cutler
b. 23 Dec 1824 d. 1852
12
Abraham Alonzo Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.23]
b. 6 Apr 1846 d. 24 Sep 1889 [
=>
]
+
Abigail Pitkin
b. 17 Jul 1797 d. 15 Mar 1847
Helga "Harriet Sanders" Ysteinsdatter
b. 7 Dec 1824 d. 5 Dec 1896
12
Harriet Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.24]
b. 8 May 1852 d. 8 May 1852
12
Hyrum Heber Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.25]
b. 6 Jul 1855 d. 4 Jun 1943
12
Eugene Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.26]
b. 15 Jan 1863 d. 14 Aug 1932
+
Margaret McMinn
b. 7 Apr 1829 d. 5 Aug 1910
Emily Trask Cutler
b. 23 Feb 1828 d. 1852
12
Isaac Alphonzo Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.27]
b. 3 Oct 1846 d. 12 Jun 1912
Amanda Trimble Gheen
b. 18 Jan 1830 d. 4 Nov 1904
12
William Gheen Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.28]
b. 3 Mar 1851 d. 24 Mar 1924
12
Albert Heber Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.29]
b. 12 Sep 1854 d. 2 Mar 1944
12
Jeremiah Heber Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.30]
b. 15 Aug 1857 bur. May 1887
12
Moroni Heber Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.31]
b. 23 May 1861 d. 21 Jan 1923
+
Hulda Barnes
b. 1 Oct 1806 d. 20 Sep 1898
Christine Golden
b. 12 Sep 1823 d. 30 Jan 1896
12
Cornelia Christine Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.32]
b. 7 Jun 1851 d. 23 Dec 1853
12
Jonathan Golden Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.33]
b. 9 Jun 1853 d. 2 Sep 1938 [
=>
]
12
Elias Smith Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.34]
b. 30 May 1857 d. 13 Jun 1934
12
Mary Margaret Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.35]
b. 30 Apr 1861 d. 28 Sep 1937
+
Sophronia Melinda Harmon
b. 5 Apr 1822 d. 21 Jan 1847
+
Mary Houston
b. 11 Sep 1818 d. 24 Dec 1896
+
Theresa Arathusa Morley
b. 18 Jul 1826 bur. 7 Oct 1855
+
Ruth Pierce
b. 11 Feb 1818 d. 28 Nov 1907
+
Laura Pitkin
b. 10 Sep 1790 d. 16 Nov 1866
Ruth Amelia Reese
b. 10 May 1817 d. 26 Nov 1902
12
Susanna R Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.36]
b. 10 Jul 1851 d. 10 Jul 1851
12
Jacob Reese Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.37]
b. 15 Apr 1853 d. 31 May 1875
12
Enoch Heber Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.38]
b. 29 Sep 1855 d. 20 Aug 1877
+
Mary Ann Shefflin
b. 31 Oct 1814 d. 26 Sep 1869
+
Abigail Buchannan
b. 9 Jan 1802
+
Elizabeth Hereford
b. Jul 1789 d. Bef 1870
+
Mary Dull
b. 23 Nov 1807
+
Dorothy Moon
b. 9 Feb 1804 d. 14 Mar 1856
+
Hannah Moon
b. 29 May 1802 d. 14 Mar 1856
+
Adelia Almira Wilcox
b. 29 Mar 1828 d. 19 Oct 1896
Mary Smithies
b. 7 Oct 1837 d. 8 Jun 1880
12
Mary Melvina Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.39]
b. 29 Aug 1858 d. 8 May 1933
12
James Heber Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.40]
b. 9 Apr 1860 d. 2 Jun 1865
12
Wilford Alfonzo Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.41]
b. 6 Oct 1863 d. 15 Nov 1928
12
Lorenzo Heber Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.42]
b. 6 Feb 1866 d. 30 Jun 1929
12
Abbie Sarah Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.43]
b. 15 Jan 1868 d. 22 Feb 1943
+
Mary Fielding
b. 21 Jul 1801 d. 21 Sep 1852
Sarah Perry Peak
b. 3 May 1811 d. 3 Dec 1873
12
Adelbert Henry Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.44]
b. 1842 d. 1843
12
Henry Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.45]
b. 1844 d. Abt 1868
12
Sarah Helen Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.46]
b. 1 Jul 1845 d. 1 Dec 1860
12
Heber Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.47]
b. 1849 d. 1850
Lucy Walker
b. 30 Apr 1826 d. 1 Oct 1910
12
Rachel Sylvia Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.48]
b. 28 Jan 1846 d. 22 Dec 1847
12
John Heber Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.49]
b. 12 Dec 1850 d. 29 Nov 1918
12
Willard Heber Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.50]
b. 25 Jan 1853 d. 5 Dec 1854
12
Lydia Holmes Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.51]
b. 18 Jan 1855 d. 15 Apr 1928
12
Anna Spaulding Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.52]
b. 18 Mar 1857 d. 26 Nov 1932
12
Eliza Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.53]
b. 14 May 1859 d. 18 May 1906
12
Joshua Heber Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.54]
b. 22 Oct 1862 d. 1863
12
Washington Heber Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.55]
b. 22 Oct 1862 d. 26 Sep 1914
12
Franklin Heber Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.56]
b. 28 Aug 1864 d. 1865
Sarah Ann Whitney
b. 22 Mar 1825 d. 4 Sep 1873
12
David Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.57]
b. 8 Mar 1846 d. 18 Aug 1847
12
David Orson Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.58]
b. 26 Aug 1848 d. 16 Apr 1849
12
David Heber Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.59]
b. 25 Feb 1850 d. 4 Oct 1927
12
Newell Whitney Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.60]
b. 19 May 1852 d. 24 Jul 1931 [
=>
]
12
Sarah Maria Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.61]
b. 4 May 1857 d. 12 Aug 1901
12
Joshua Heber Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.62]
b. 23 Feb 1861 d. 6 Apr 1925
Prescinda Lothrop Huntington
b. 7 Sep 1810 d. 1 Feb 1892
12
Prescindia Celestia Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.63]
b. 9 Jan 1849 d. 9 May 1850
12
Joseph Smith Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.64]
b. 22 Dec 1851 d. 29 Mar 1936
+
Sarah Shuler
b. 15 May 1801 d. 25 Jan 1879
+
Rebecca Swain
b. 3 Aug 1798 d. 25 Sep 1861
Martha McBride
b. 17 Mar 1805 d. 20 Nov 1901
12
Son Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.3.65]
b. 13 Jan 1847 d. 13 Jan 1847
+
Elizabeth Doty
b. 29 Apr 1808 d. 21 Jan 1889
11
Melvina Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.4]
b. 1803 d. 1826
11
Solomon F Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.5]
b. 7 Feb 1805 d. 4 Feb 1878
11
Daniel B Kimball
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.3.6]
b. 1807 d. 28 Dec 1879
10
Maxwell Spaulding
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.4]
b. Abt 1771
10
Dorothy Spaulding
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.5]
b. Abt 1772
10
Eunice Spaulding
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.6]
b. Abt 1772 d. 6 Jun 1829
10
Thomas Spalding
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.7]
b. 1775
10
Abigail Spalding
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.8]
b. Abt 1776
10
Experience Spaulding
[1.1.4.1.1.1.2.3.1.9]
b. 1778 d. 26 Sep 1841
8
Martha Colt
[1.1.4.1.1.1.2.4]
b. Abt 1713
8
Isaac Coit
[1.1.4.1.1.1.2.5]
b. 26 Dec 1714 d. 23 Apr 1776
8
Mary Colt
[1.1.4.1.1.1.2.6]
b. 1717
8
William Coit
[1.1.4.1.1.1.2.7]
b. 1720 d. Bef 1776
8
Daniel Coit
[1.1.4.1.1.1.2.8]
b. Abt 1724 d. 14 Apr 1762
8
Experience Wheeler Coit
[1.1.4.1.1.1.2.9]
b. Abt 1726 d. 20 Feb 1767
7
William Coit
[1.1.4.1.1.1.3]
b. 25 Jan 1675 d. 7 May 1703
7
Solomon Coit
[1.1.4.1.1.1.4]
b. 29 Nov 1679 d. Abt 1753
7
Samuel Coit
[1.1.4.1.1.1.5]
b. Abt 1692 d. 28 Feb 1753
6
Mary Harris
[1.1.4.1.1.2]
b. 1 Jul 1645 d. 30 Aug 1721
6
Hannah Harris, I
[1.1.4.1.1.3]
b. 1 Mar 1646 d. 3 Aug 1722
6
Patience Harris
[1.1.4.1.1.4]
b. Abt 1648 d. 19 Mar 1732
6
Elizabeth Harris
[1.1.4.1.1.5]
b. Abt 1649 d. 7 Oct 1694
5
Eleanor Harris
[1.1.4.1.2]
b. 1635 d. 28 Jun 1650
5
Mary Harris
[1.1.4.1.3]
b. 1639 d. 14 Dec 1722
Samuel Whipple
c. 17 Mar 1644 d. 12 Mar 1711
6
Noah Whipple
[1.1.4.1.3.1]
b. Abt 1667 d. 10 Nov 1703
Susannah
b. Abt 1665
7
Susannah Whipple
[1.1.4.1.3.1.1]
b. Abt 1691 d. 21 Jan 1720
7
Abraham Whipple
[1.1.4.1.3.1.2]
b. 1693
7
Noah Whipple, Jr
[1.1.4.1.3.1.3]
b. 18 Dec 1697 d. 29 Feb 1784
Mary Dexter
b. 1699
8
Freelove Whipple
[1.1.4.1.3.1.3.1]
b. 1736
Benjamin Pitts
b. 6 Nov 1754
9
James Pitts
[1.1.4.1.3.1.3.1.1]
b. 5 Dec 1780
9
Marcy Whipple Pitts
[1.1.4.1.3.1.3.1.2]
b. 14 Dec 1783
8
Susannah Whipple
[1.1.4.1.3.1.3.2]
b. Abt 1723 d. 1804
Elisha Angell
b. 13 Oct 1719 d. 14 Nov 1755
9
Enoch Angell
[1.1.4.1.3.1.3.2.1]
b. 15 Oct 1742 d. 17 Feb 1832
Amey Randall
b. Abt May 1751 d. 17 Dec 1767
10
Randall Angell
[1.1.4.1.3.1.3.2.1.1]
b. 30 Nov 1767 d. 5 Sep 1855
Marcy Angell
b. 5 Nov 1767 d. 5 Apr 1837
11
Dexter Angell
[1.1.4.1.3.1.3.2.1.1.1]
b. 28 May 1790 d. 17 Nov 1841
11
Amey Angell
[1.1.4.1.3.1.3.2.1.1.2]
b. 4 Apr 1791
11
Whipple Angell
[1.1.4.1.3.1.3.2.1.1.3]
b. 6 Oct 1794 d. 2 Jul 1862
11
Selena Angell
[1.1.4.1.3.1.3.2.1.1.4]
b. 5 Jul 1796
11
Brown Angell
[1.1.4.1.3.1.3.2.1.1.5]
b. 13 Oct 1801 d. 3 Aug 1878
11
Julianna Angell
[1.1.4.1.3.1.3.2.1.1.6]
b. 16 Apr 1804 d. 22 May 1836
11
Olney Angell
[1.1.4.1.3.1.3.2.1.1.7]
b. 16 Dec 1808
11
Esten Angell
[1.1.4.1.3.1.3.2.1.1.8]
b. 16 Dec 1808 d. 19 Mar 1889
Freelove Randall
b. 16 Jun 1749 d. 7 Feb 1778
10
Elisha Angell
[1.1.4.1.3.1.3.2.1.2]
b. 21 May 1770 d. 25 Feb 1846
Abigail Cushing
b. 1773 d. 11 Feb 1843
11
Cushing Angell
[1.1.4.1.3.1.3.2.1.2.1]
b. 7 Dec 1794 d. 4 Jun 1886
Mahala Pearce
b. 10 Apr 1795 d. 24 Nov 1877
12
Mercy A. Angell
[1.1.4.1.3.1.3.2.1.2.1.1]
b. 9 Aug 1834 d. 23 Mar 1877
12
Amos Pearce Angell
[1.1.4.1.3.1.3.2.1.2.1.2]
b. 19 Jun 1836 d. 3 Jun 1840
11
Alfred Angell
[1.1.4.1.3.1.3.2.1.2.2]
b. 24 Aug 1796 d. 15 May 1867
+
Mary Cushing
+
Julia A Hawkins
b. 1813
11
Stephen Angell
[1.1.4.1.3.1.3.2.1.2.3]
b. 31 Dec 1798 d. 18 Mar 1859
11
Shadrach Angell
[1.1.4.1.3.1.3.2.1.2.4]
b. 22 May 1801 d. 10 Aug 1838
11
Freelove Angell
[1.1.4.1.3.1.3.2.1.2.5]
b. 9 Jun 1805 d. 1889
11
Mary Cushing Angell
[1.1.4.1.3.1.3.2.1.2.6]
b. 17 Jun 1808 d. 17 Jun 1808
10
Stephen Angell
[1.1.4.1.3.1.3.2.1.3]
b. Abt 20 Mar 1776 d. 1 Feb 1818
10
Nathaniel Angel
[1.1.4.1.3.1.3.2.1.4]
b. 12 Mar 1780 d. 3 Aug 1832
Asha Smith
b. 23 Sep 1800 d. 20 Oct 1870
11
Amey Randall Angell
[1.1.4.1.3.1.3.2.1.4.1]
b. 8 Aug 1827 d. 28 Mar 1920
Obadiah Brown
b. 30 Nov 1823 d. 2 Feb 1907
12
Anna M Brown
[1.1.4.1.3.1.3.2.1.4.1.1]
b. 1851
12
Mary L Brown
[1.1.4.1.3.1.3.2.1.4.1.2]
b. 1858 d. 31 May 1876
12
Mabel Brown
[1.1.4.1.3.1.3.2.1.4.1.3]
b. 1862 d. 8 Jun 1928
12
Adelaide V Brown
[1.1.4.1.3.1.3.2.1.4.1.4]
b. 1867 d. 20 Feb 1929
11
Ann Maria Angell
[1.1.4.1.3.1.3.2.1.4.2]
b. Abt 28 May 1829 d. 19 Feb 1833
9
Mary Angel
[1.1.4.1.3.1.3.2.2]
b. 4 Oct 1744
Jonathan Comstock
b. 7 Sep 1737 d. 4 Dec 1784
10
Felix Comstock
[1.1.4.1.3.1.3.2.2.1]
b. 1770 d. 22 Jul 1822
10
Thomas Comstock
[1.1.4.1.3.1.3.2.2.2]
b. 7 May 1775 d. 7 Sep 1834
10
Ichabod Comstock
[1.1.4.1.3.1.3.2.2.3]
b. 1776 bur. Jan 1775
10
Lucy Comstock
[1.1.4.1.3.1.3.2.2.4]
b. 1778
9
Abner Angell
[1.1.4.1.3.1.3.2.3]
b. 1746
+
Almyra Whitman
b. 1782
9
Martha Angell
[1.1.4.1.3.1.3.2.4]
b. Abt 19 May 1750 d. 8 Jun 1790
David Soule
b. 1741
10
Thomas Soule
[1.1.4.1.3.1.3.2.4.1]
b. 1784
10
Constant Soule
[1.1.4.1.3.1.3.2.4.2]
b. 14 May 1785
10
Samuel Soule
[1.1.4.1.3.1.3.2.4.3]
b. 1796
9
Isaac Angell
[1.1.4.1.3.1.3.2.5]
b. 17 Jul 1753 d. 9 Dec 1831
Salley Williams
b. 1760
10
James Angell
[1.1.4.1.3.1.3.2.5.1]
b. Abt 1781 d. 20 Nov 1870
10
Susanna Angell
[1.1.4.1.3.1.3.2.5.2]
b. 12 May 1782 d. 22 May 1837
10
Robert Angell
[1.1.4.1.3.1.3.2.5.3]
b. 15 Mar 1786 d. 14 Nov 1862
10
Anna Angell
[1.1.4.1.3.1.3.2.5.4]
b. Dec 1788 d. 14 Apr 1832
10
Sarah Williams Angell
[1.1.4.1.3.1.3.2.5.5]
b. Abt 12 Feb 1791 d. 20 Jul 1810
10
Elizabeth Williams Angell
[1.1.4.1.3.1.3.2.5.6]
b. Abt 6 May 1793 d. 25 Oct 1810
James Angell
b. 31 May 1731 d. Jun 1806
9
Sally Angell
[1.1.4.1.3.1.3.2.6]
b. 30 Oct 1757
8
Mary Whipple
[1.1.4.1.3.1.3.3]
b. Abt 1729 d. 12 Sep 1805
8
Commodore Abraham Whipple
[1.1.4.1.3.1.3.4]
b. 26 Sep 1732 d. 27 May 1819
Sarah Hopkins
b. 26 Sep 1739 d. 14 Oct 1818
9
Catherine Whipple
[1.1.4.1.3.1.3.4.1]
b. Abt 1762 d. 1834
Ebenezer Sproat
b. 9 Feb 1752 d. 29 Aug 1819
10
Sarah Whipple Sproat
[1.1.4.1.3.1.3.4.1.1]
b. 28 Jan 1782 d. 22 Jan 1851
9
Captain John Hopkins Whipple
[1.1.4.1.3.1.3.4.2]
b. 2 Jul 1765
9
Mary Whipple
[1.1.4.1.3.1.3.4.3]
b. Abt 1767 d. 15 Aug 1831
Ezekiel Comstock
b. 17 Jan 1762 d. Abt 27 Feb 1828
10
Elizabeth Carter Comstock
[1.1.4.1.3.1.3.4.3.1]
b. 1792 d. 29 Sep 1822
10
Sarah Ann Comstock
[1.1.4.1.3.1.3.4.3.2]
b. 21 Jan 1795 d. 29 Sep 1854
10
William Whipple Comstock
[1.1.4.1.3.1.3.4.3.3]
b. 23 Mar 1801 d. 20 Oct 1878
8
Samuel Whipple
[1.1.4.1.3.1.3.5]
b. Abt 1740 d. 6 Feb 1827
Elizabeth Snow
b. 28 Sep 1739 d. 22 Sep 1806
9
Noah Whipple
[1.1.4.1.3.1.3.5.1]
b. 15 Feb 1772
9
Samuel Whipple, Jr
[1.1.4.1.3.1.3.5.2]
b. 4 Jul 1774 d. 9 Nov 1843
Mary Chaffee
b. 1779 d. 12 Mar 1828
10
Lucy A Whipple
[1.1.4.1.3.1.3.5.2.1]
b. 4 May 1800 d. 18 Apr 1887
10
John N Whipple
[1.1.4.1.3.1.3.5.2.2]
b. 1801 d. 29 Dec 1865
10
Joseph H Whipple
[1.1.4.1.3.1.3.5.2.3]
b. 3 May 1803 d. 1 Aug 1891
10
Sarepta Whipple
[1.1.4.1.3.1.3.5.2.4]
b. 16 Aug 1808 d. 5 Nov 1840
10
Sabrina Whipple
[1.1.4.1.3.1.3.5.2.5]
b. 1808 d. 1900
+
Gurdon Barrows
b. 26 Feb 1796 d. 23 Aug 1877
10
Reuben Chaffee Whipple
[1.1.4.1.3.1.3.5.2.6]
b. 1809 d. 21 Jan 1828
10
Jonathan C Whipple
[1.1.4.1.3.1.3.5.2.7]
b. 1811
10
Mary Ann Whipple
[1.1.4.1.3.1.3.5.2.8]
b. 1814
10
Samuel A Whipple
[1.1.4.1.3.1.3.5.2.9]
b. 1815 d. 1886
10
Gustavus A Whipple
[1.1.4.1.3.1.3.5.2.10]
b. 1816
10
Elizabeth S Whipple
[1.1.4.1.3.1.3.5.2.11]
b. 1822
10
Martha B Whipple
[1.1.4.1.3.1.3.5.2.12]
b. 1823 d. 1894
9
Sarah Whipple
[1.1.4.1.3.1.3.5.3]
b. 1776 d. 21 Jan 1824
Aaron Rice
b. 11 Nov 1768 d. 11 Jul 1822
10
Samuel Rice
[1.1.4.1.3.1.3.5.3.1]
b. 20 Apr 1798 d. 10 Oct 1892
10
Harvey Rice
[1.1.4.1.3.1.3.5.3.2]
b. 1800 d. 23 Sep 1848
10
Harriet Rice
[1.1.4.1.3.1.3.5.3.3]
b. 13 Aug 1805 d. 31 Mar 1867
10
Roxanna Rice
[1.1.4.1.3.1.3.5.3.4]
b. 1808
10
Sabrina Celestina Rice
[1.1.4.1.3.1.3.5.3.5]
b. 1810 d. 1863
10
Sally Rice
[1.1.4.1.3.1.3.5.3.6]
b. 1811
10
Willard Rice
[1.1.4.1.3.1.3.5.3.7]
b. 1812
10
Sarah Rice
[1.1.4.1.3.1.3.5.3.8]
b. 1814 d. 22 Apr 1833
10
Anna Rice
[1.1.4.1.3.1.3.5.3.9]
b. 1816
9
Hopestill Whipple
[1.1.4.1.3.1.3.5.4]
b. 3 Oct 1778 d. 21 Mar 1860
7
Daniel Whipple
[1.1.4.1.3.1.4]
b. Abt 1703 d. 29 Dec 1789
Mary Smith
b. 3 Aug 1704
8
Mercy Whipple
[1.1.4.1.3.1.4.1]
b. 20 Jan 1726 d. 7 Dec 1815
8
Enock Whipple
[1.1.4.1.3.1.4.2]
b. Abt 1729
8
Jonathan Whipple
[1.1.4.1.3.1.4.3]
b. Abt 1731 d. 13 Apr 1805
8
Mary Whipple
[1.1.4.1.3.1.4.4]
b. Abt 1735 d. 6 Dec 1823
Oliver Blackinton
b. 1734 d. 16 Dec 1811
9
Othneil Blackinton
[1.1.4.1.3.1.4.4.1]
b. 10 May 1758 d. 20 Aug 1804
Chloe Holmes
b. 7 May 1760 d. 18 Apr 1825
10
Ellis Blackinton
[1.1.4.1.3.1.4.4.1.1]
b. 18 Mar 1783 d. 1870
Mary Jackson
b. 17 Feb 1787 d. 1859
11
James Othneil Blackinton
[1.1.4.1.3.1.4.4.1.1.1]
b. 8 Apr 1812
Julia W Day
b. 4 Jul 1813
12
Frances M Blackinton
[1.1.4.1.3.1.4.4.1.1.1.1]
b. 1836
11
Julia W Blackinton
[1.1.4.1.3.1.4.4.1.1.2]
b. 1815
11
Frances M Blackinton
[1.1.4.1.3.1.4.4.1.1.3]
b. 1836
10
Lemuel W Blackinton
[1.1.4.1.3.1.4.4.1.2]
b. 8 Jun 1785 d. 2 Jul 1868
Philenia Richards
b. 20 Aug 1791 d. 16 Mar 1811
11
Nathan Richards Blackinton
[1.1.4.1.3.1.4.4.1.2.1]
b. 10 Mar 1811
Mary Ann Cutting
b. 1815
12
James Oliver Orlander Blackinton
[1.1.4.1.3.1.4.4.1.2.1.1]
b. 12 Jun 1837 d. 1864
12
Esther R Blackinton
[1.1.4.1.3.1.4.4.1.2.1.2]
b. 1841 d. 10 Jul 1924
12
James Ellis Blackinton
[1.1.4.1.3.1.4.4.1.2.1.3]
b. 26 Oct 1843
12
Hannah Blackinton
[1.1.4.1.3.1.4.4.1.2.1.4]
b. 7 Sep 1846
12
Sara Annette Blackinton
[1.1.4.1.3.1.4.4.1.2.1.5]
b. 11 Mar 1849
12
Herbert Tisdale Blackinton
[1.1.4.1.3.1.4.4.1.2.1.6]
b. 1 Nov 1850 d. 22 Nov 1933
12
Sebastian Blackinton
[1.1.4.1.3.1.4.4.1.2.1.7]
b. 1853 d. 18 Apr 1889 [
=>
]
12
Maria Elizabeth Blackinton
[1.1.4.1.3.1.4.4.1.2.1.8]
b. 11 Nov 1856
12
Marsha Blackinton
[1.1.4.1.3.1.4.4.1.2.1.9]
b. 1857
Esther Cheever
b. 4 Mar 1785 d. 21 Feb 1861
11
Abigail Eliza Blackinton
[1.1.4.1.3.1.4.4.1.2.2]
b. 9 Jun 1815 d. 30 May 1877
+
John White, Jr
b. 31 Jan 1809 d. 22 Aug 1876
11
Lemuel Nelson Blackinton
[1.1.4.1.3.1.4.4.1.2.3]
b. 21 Dec 1816 d. 1879
Susan Fletcher Guild
b. 3 Oct 1823 d. 1851
12
Susan Emily Blackinton
[1.1.4.1.3.1.4.4.1.2.3.1]
b. 22 Apr 1847 [
=>
]
12
Ella Frances Blackinton
[1.1.4.1.3.1.4.4.1.2.3.2]
b. Abt 1864 [
=>
]
11
Emily Morse Blackinton
[1.1.4.1.3.1.4.4.1.2.4]
b. 2 Sep 1821
Lewis Tiffany
b. 6 Jun 1819 d. 12 Jun 1898
12
James L Tiffany
[1.1.4.1.3.1.4.4.1.2.4.1]
b. 1845 [
=>
]
12
Harriet L Tiffany
[1.1.4.1.3.1.4.4.1.2.4.2]
b. 13 Jan 1848 [
=>
]
12
Maria Elizabeth Tiffany
[1.1.4.1.3.1.4.4.1.2.4.3]
b. 11 Oct 1849
12
Frederick White Tiffany
[1.1.4.1.3.1.4.4.1.2.4.4]
b. 1 Sep 1855 d. 1903 [
=>
]
12
Calista E Tiffany
[1.1.4.1.3.1.4.4.1.2.4.5]
b. 1858
12
Robert Frasier Tiffany
[1.1.4.1.3.1.4.4.1.2.4.6]
b. Nov 1864 [
=>
]
10
Charlotte G Blackinton
[1.1.4.1.3.1.4.4.1.3]
b. 2 Mar 1796 d. 6 Jan 1863
+
Samuel Parnell Fisher
b. 4 Aug 1795 d. 1863
10
Eliza Blackinton
[1.1.4.1.3.1.4.4.1.4]
b. 7 Oct 1802 d. 1882
Nelson H Morse
b. 24 Aug 1798 d. 1854
11
Julia M Morse
[1.1.4.1.3.1.4.4.1.4.1]
b. 13 Feb 1826
11
James Nelson Morse
[1.1.4.1.3.1.4.4.1.4.2]
b. 13 Feb 1826 d. 16 Nov 1899
9
Oliver Blackinton
[1.1.4.1.3.1.4.4.2]
b. 13 Feb 1761 d. 3 Apr 1810
Molly Daggett
b. 21 May 1766 d. 1829
10
Catherine Blackinton
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.1]
b. 22 Jan 1785 d. 2 Aug 1862
Sewell Stanley
b. 22 Jul 1787 d. 26 Feb 1849
11
Oliver Stanley
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.1.1]
b. 14 Feb 1814
Emelia Whitney
b. 6 Feb 1812 d. 1 Apr 1852
12
Fredrick Martin Stanley
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.1.1.1]
b. 15 Mar 1843 d. 15 Aug 1877
12
Annie Frances Stanley
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.1.1.2]
b. 8 Mar 1845 [
=>
]
12
Emily Whitney Stanley
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.1.1.3]
b. 10 Mar 1852
11
Carlos Stanley
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.1.2]
b. 24 Oct 1815
11
Sarah Ann Stanley
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.1.3]
b. 9 Feb 1817
11
Eleanor Stanley
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.1.4]
b. 22 Jun 1818
Isaac Bailey
b. 11 May 1814 d. 28 Jun 1856
12
Irving I Bailey
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.1.4.1]
b. 17 Jan 1846 d. 10 May 1854
12
Catharine Stanley Bailey
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.1.4.2]
b. 30 Jun 1848
12
Annie Bailey
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.1.4.3]
b. 1850
12
Anna C Bailey
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.1.4.4]
b. 1852
10
Levi W Blackinton
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.2]
b. 2 Aug 1788 d. 18 Jul 1851
Harriot Prescott
11
Peleg Benson Blackinton
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.2.1]
b. 6 Nov 1820 d. 29 Mar 1858
Agnes Thissell
b. 1828
12
Frank W Blackinton
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.2.1.1]
b. May 1851 [
=>
]
12
Caroline M Blackington
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.2.1.2]
b. 19 Feb 1856 d. 7 May 1888
11
Harriet Octava Blackinton
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.2.2]
b. 10 Feb 1825 d. 20 Jun 1903
Chris Hackett
b. 1820
12
Clarabel Hackett
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.2.2.1]
b. 1849
12
Jean Albert Hackett
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.2.2.2]
b. 9 Feb 1858 d. 29 Jul 1898
11
Charles Williard Blackinton
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.2.3]
b. 25 Mar 1829
10
Nancy Blackinton
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.3]
b. 23 Dec 1790 d. 18 Oct 1868
Lemuel Whiting
b. 12 Dec 1776 d. 30 Sep 1822
11
Mary Ann Blackinton Whiting
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.3.1]
b. 7 May 1812
11
William Dean Whiting
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.3.2]
b. 23 Dec 1815 d. 24 Nov 1891
Rebecca Damon Butterfield
b. 8 May 1818
12
William Osborne Whiting
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.3.2.1]
b. 30 Sep 1846 d. 28 Apr 1851
12
Frank M Whiting
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.3.2.2]
b. 21 Apr 1849 d. 28 May 1892 [
=>
]
12
Josephine S Whiting
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.3.2.3]
b. 1852
12
Florence Rebecca Whiting
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.3.2.4]
b. 23 Apr 1857 d. 20 Mar 1907
11
Nancy Whiting
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.3.3]
b. 4 Feb 1818 d. 17 Sep 1819
11
Levi Willard Whiting
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.3.4]
b. 27 Mar 1821 d. 4 May 1873
Nancy
b. Abt 1819
12
Wilhelmina Knight Whiting
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.3.4.1]
b. 17 Apr 1849 [
=>
]
10
Mary Blackinton
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.4]
b. 26 Jun 1793
+
William Thayer Dean
b. 12 Aug 1787 d. 24 Sep 1826
10
Olive D Blackinton
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.5]
b. 7 Sep 1795 d. 25 Oct 1847
Calvin Richards
b. 30 Dec 1793 d. 9 Apr 1873
11
Emily Augusta Richards
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.5.1]
b. 1 Dec 1817
David Capron
b. 20 Dec 1812 d. 18 Mar 1879
12
Henry E Capron
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.5.1.1]
b. 29 Jun 1840 [
=>
]
12
Louise Capron
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.5.1.2]
b. Abt 1841
12
Frank Richard Capron
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.5.1.3]
b. 1 Apr 1844
12
Louisa A Capron
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.5.1.4]
b. 22 Dec 1846
11
Anna Maria Richards
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.5.2]
b. 16 Aug 1819 d. 1899
Abial Codding
b. 29 Jan 1817 d. 1901
12
Arthur E Codding
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.5.2.1]
b. 1843 d. 1900 [
=>
]
12
Ella M Codding
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.5.2.2]
b. 26 Feb 1845 d. 4 Jul 1846
12
Edwin A Codding
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.5.2.3]
b. 1854 d. 1923 [
=>
]
12
James Albert Codding
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.5.2.4]
b. 7 Oct 1849 d. 9 Sep 1910 [
=>
]
12
Ellen Louisa Codding
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.5.2.5]
b. 28 Nov 1860 d. 27 Jan 1879
11
Francis B Richards
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.5.3]
b. 5 May 1825
Juila M Peck
b. 1828 d. 7 Sep 1853
12
Hattie Olive Richards
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.5.3.1]
b. Abt 1847
12
Annie Richards
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.5.3.2]
b. Abt 1849
10
Azuba Blackinton
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.6]
b. 15 Dec 1797 d. 9 May 1832
John Tifft
b. 10 Sep 1800 d. 29 Jun 1851
11
Maria Tifft
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.6.1]
b. Abt 1823
+
Silas Tyler
b. 24 Jun 1820 d. 7 Dec 1868
11
Frances Leonard Tifft
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.6.2]
b. 1 Nov 1824 d. 22 Sep 1877
Clemence de Girardin
b. 1837
12
Henry Leonard Tifft
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.6.2.1]
b. 18 Nov 1862 d. 26 Dec 1911 [
=>
]
11
Frank Tifft
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.6.3]
b. Abt 1828
10
Oliver Blackinton
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.7]
b. 6 Aug 1800
10
Aaron Blackinton
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.8]
b. 8 Apr 1803
10
Chloe Blackinton
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.9]
b. 13 Jul 1805 d. 1854
Enoch F Goodhue
b. Mar 1800 d. 1863
11
Henry Goodhue
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.9.1]
b. 8 Sep 1825 d. 1888
Mary Ann Shannon
b. 1828 d. 1887
12
George Alfred Goodhue
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.9.1.1]
b. Oct 1843 d. 1889
12
Ella M Goodhue
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.9.1.2]
b. 1856 d. Aft 1885 [
=>
]
12
Carrie Augusta Goodhue
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.9.1.3]
b. Feb 1857 d. 1913 [
=>
]
11
Mary Blackinton Goodhue
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.9.2]
b. Jun 1828 d. 1845
11
Carlos Augustus Goodhue
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.9.3]
b. 6 Feb 1831 d. 1872
+
Sarah Ann Coburn
b. 17 Sep 1833 d. 22 Oct 1871
11
Cornelius Goodhue
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.9.4]
b. 1 Aug 1835 d. 1866
11
Emily Angelia Goodhue
[1.1.4.1.3.1.4.4.2.9.5]
b. 20 Jul 1837 d. 1878
+
Samuel N Harris
9
Levi Blackinton
[1.1.4.1.3.1.4.4.3]
b. 23 Jun 1763 d. 1783
9
Aaron Blackinton
[1.1.4.1.3.1.4.4.4]
b. 28 Mar 1774 d. 2 Dec 1802
Sarah Aldis
b. 3 Mar 1773 d. 1849
10
Esther Blackinton
[1.1.4.1.3.1.4.4.4.1]
b. 9 Dec 1798
Abijah Hall
b. 1797 d. 1860
11
Roxellana Ann Hall
[1.1.4.1.3.1.4.4.4.1.1]
b. 6 Sep 1824
11
Esther Maria Alldin Hall
[1.1.4.1.3.1.4.4.4.1.2]
b. 14 Dec 1826
11
Samuel Hall
[1.1.4.1.3.1.4.4.4.1.3]
b. 1829
11
Elizabeth Hall
[1.1.4.1.3.1.4.4.4.1.4]
b. 1832
11
Louisa Hall
[1.1.4.1.3.1.4.4.4.1.5]
b. 1835
11
Caroline Hall
[1.1.4.1.3.1.4.4.4.1.6]
b. 1840
10
Caroline Blackinton
[1.1.4.1.3.1.4.4.4.2]
b. 20 May 1801
9
Olive Blackinton
[1.1.4.1.3.1.4.4.5]
b. 8 Dec 1755 d. 14 Nov 1827
Henry Richardson
b. 7 Aug 1752 d. 4 Nov 1827
10
Olive Blackinton "Ollie" Richardsen
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1]
b. 20 Aug 1775 d. Aft 1850
Thomas McGrath
b. 1768 d. 27 Jun 1845
11
Clarissa Richardson McGrath
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.1]
b. 24 Oct 1796 d. 24 Feb 1887
James P Chute
b. 28 Jun 1796 d. 9 Jan 1898
12
Andrew Hossom Chute
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.1.1]
b. 19 Nov 1812 d. 30 Nov 1893 [
=>
]
12
Olive C Chute
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.1.2]
b. 1816 d. 22 May 1883 [
=>
]
12
James P Chute
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.1.3]
b. Abt 1817 [
=>
]
12
Mary M Chute
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.1.4]
b. Abt 1824 d. 1894 [
=>
]
12
Abraham G Chute
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.1.5]
b. Abt 1831 d. 7 Nov 1861 [
=>
]
12
Jacob Chute
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.1.6]
b. Abt 1833
12
Isaac Chute
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.1.7]
b. Abt 1833
11
Nancy McGrath
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.2]
b. 26 Mar 1800 d. 7 May 1827
Isaac Whitehouse
b. 18 Dec 1793 d. 6 May 1871
12
John Whitehouse
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.2.1]
b. Abt 1818 [
=>
]
12
Robert Whitehouse
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.2.2]
b. 31 May 1821 d. 4 Nov 1894 [
=>
]
12
Eliza Ann Whitehouse
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.2.3]
b. 1823 d. Abt 1895 [
=>
]
12
Abraham Whitehouse
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.2.4]
b. Abt 1825
12
Solomon Whitehouse
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.2.5]
b. Abt 1827
11
Sophronia Richardson McGrath
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.3]
b. 16 Feb 1802 d. 1872
Andrew Tyson
b. Abt 1800
12
Mary Tyson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.3.1]
b. 14 Dec 1827 d. 21 Feb 1917 [
=>
]
11
Cyrus McGrath
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.4]
b. 6 May 1804 d. 1874
Philinda W Cross
b. 1809 d. 1887
12
Alpheus C McGrath
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.4.1]
b. 16 Oct 1828 d. 12 Jul 1911 [
=>
]
12
Celena McGrath
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.4.2]
b. 1832
12
Clarissa McGrath
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.4.3]
b. Abt 1832 [
=>
]
12
Phebe McGrath
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.4.4]
b. Abt 1835
12
Olive McGrath
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.4.5]
b. Abt 1838
12
Thomas Debby McGrath
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.4.6]
b. 18 Sep 1840 d. 4 Sep 1868
11
Azubah McGrath
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.5]
b. 8 Apr 1806 d. 22 Mar 1875
William Hempfield
b. 7 Aug 1795 d. 17 Apr 1880
12
Isaac Whitehouse Hempfield
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.5.1]
b. 1824 d. 3 Nov 1900
12
Thomas Hempfield
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.5.2]
b. Mar 1827 d. 11 Jun 1902 [
=>
]
12
Nancy Hempfield
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.5.3]
b. 14 Mar 1829 d. 17 Oct 1901 [
=>
]
12
Henry Hempfield
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.5.4]
b. 19 Apr 1831 d. 17 Feb 1915 [
=>
]
12
Mary Catharine Hempfield
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.5.5]
b. 1833
12
Francis M Hempfield
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.5.6]
b. 1837
12
Robert Hempfield
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.5.7]
b. 1839 d. 8 Oct 1857
12
William Hempfield
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.5.8]
b. 24 Dec 1840 [
=>
]
12
Edward Hempfield
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.5.9]
b. 24 Dec 1844 d. 9 Sep 1864
12
Joseph G Hempfield
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.5.10]
b. 1846 d. 2 Sep 1854
11
Thomas Richardson McGrath
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.6]
b. 10 Apr 1808 d. 6 Dec 1889
Matilda Agnes Linkens
b. 15 May 1815 d. 10 Dec 1885
12
Olive L McGrath
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.6.1]
b. 25 Sep 1835 d. 6 Feb 1865 [
=>
]
12
Mary Elizabeth McGrath
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.6.2]
b. 1837 d. Abt 1845
12
Jackson McGrath
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.6.3]
b. 1838 d. Abt 1845
12
Nancy Jane McGrath
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.6.4]
b. 30 Jun 1839 d. 4 Feb 1917 [
=>
]
12
Emily McGrath
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.6.5]
b. 8 Jan 1843 d. 19 Jun 1923 [
=>
]
12
Thomas Richard McGrath
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.6.6]
b. 24 May 1845 d. 13 Apr 1933 [
=>
]
12
Henry L McGrath
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.6.7]
b. 1847 d. 1922
12
Perry McGrath
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.6.8]
b. 1849 d. Abt 1859
12
Dallas W McGrath
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.6.9]
b. Sep 1851 d. 15 Sep 1906 [
=>
]
12
Clarissa Matilda McGrath
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.6.10]
b. 12 Aug 1853 d. 14 Nov 1934 [
=>
]
12
Otis Nelson McGrath
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.6.11]
b. 18 Jun 1856 d. 21 Sep 1932 [
=>
]
12
Frances E McGrath
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.6.12]
b. Aug 1858 d. 1942 [
=>
]
11
Whitney Whittington McGrath
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.7]
b. 19 Apr 1810 d. 4 Aug 1852
Mary Ann Holwell
b. 15 Sep 1807 d. 18 Jan 1892
12
Mary V McGrath
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.7.1]
b. 1839 [
=>
]
12
Harriet R McGrath
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.7.2]
b. Apr 1841 d. 1914
12
Eliza C McGrath
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.7.3]
b. 1843 d. 1907
12
Charles W McGrath
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.7.4]
b. 1845 d. 1950
12
Arthur Burt McGrath
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.7.5]
b. Apr 1851 d. 9 May 1916
11
Alvenia Richardson McGrath
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.8]
b. 5 Dec 1810 d. 16 Jul 1884
James O'Hara Henry Lutgen
b. 29 May 1810 d. 22 Nov 1879
12
Caroline B Lutgen
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.8.1]
b. 23 Aug 1832 d. 4 Jul 1891 [
=>
]
12
Sidney B Lutgen
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.8.2]
b. 30 Jun 1834 d. 14 Feb 1927 [
=>
]
12
Lorinda F "Rinda" Lutgen
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.8.3]
b. 3 Sep 1836 d. 5 Apr 1909 [
=>
]
12
Julianne "Julia" Lutgen
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.8.4]
b. 18 Sep 1838 d. 18 Sep 1913
12
Athenus Lutgen
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.8.5]
b. 9 Oct 1840 d. 14 Sep 1886 [
=>
]
12
Almyra Alvernia Lutgen
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.8.6]
b. 17 Oct 1842 d. 18 Dec 1924 [
=>
]
12
Mary Clarissa Lutgen
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.8.7]
b. 16 May 1845 d. 26 Oct 1888 [
=>
]
12
James Cicero Lutgen
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.8.8]
b. 30 Apr 1848 d. 1895 [
=>
]
12
Daughter Lutgen
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.8.9]
b. Abt 1850
11
Horatio Richardson McGrath
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.9]
b. Feb 1813 d. 12 Jun 1880
Margaret Ann Keller
b. 28 Feb 1816 d. 1891
12
John L McGrath
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.9.1]
b. 1833 d. Feb 1863 [
=>
]
12
Lewis K McGrath
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.9.2]
b. 21 May 1836 d. 19 Apr 1923 [
=>
]
12
Lovina McGrath
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.9.3]
b. 1839 d. 1866
12
Lucinda "Cinderella" McGrath
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.9.4]
b. Abt 1841 [
=>
]
12
Hiram McGrath
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.9.5]
b. 9 Nov 1842 d. 25 Jan 1934 [
=>
]
12
George K McGrath
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.9.6]
b. 3 Apr 1846 d. 4 Aug 1922 [
=>
]
12
Isaac McGrath
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.9.7]
b. 28 Dec 1848 d. 16 Jul 1935 [
=>
]
12
Gail McGrath
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.9.8]
b. 1849
12
Horatio Mcgrath
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.9.9]
b. Abt 1851 [
=>
]
12
Henry L McGrath
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.9.10]
b. 12 Jun 1853 d. 24 Jul 1922 [
=>
]
12
Charles Luther McGrath
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.9.11]
b. 26 Mar 1856 d. 21 Jun 1918 [
=>
]
12
Benjamin Franklin McGrath
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.9.12]
b. 28 Apr 1859 d. 17 Apr 1939
12
Daniel McGrath
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.9.13]
b. Abt 1861
+
Philinda W Cross
b. 1809 d. 1887
11
Mary Richardson McGrath
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.10]
b. 1816 d. 1868
Henry Linkens
b. 1811
12
William F Linkens
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.10.1]
b. Abt 1838
12
Sarah Frances Linkens
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.10.2]
b. 1840 d. 9 Mar 1926 [
=>
]
12
Harriet E Linkens
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.10.3]
b. Abt 1842
12
Robert W Linkens
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.10.4]
b. Abt 1848
12
Mary Linkens
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.1.10.5]
b. Abt 1857
10
Henry Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.2]
b. 29 Nov 1777 d. 24 Jul 1836
Deborah Bareton
b. 1779
11
Sophronia Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.2.1]
b. 1800
11
Eveline Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.2.2]
b. 1803
11
Maria Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.2.3]
b. 26 Oct 1805
11
Abigail Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.2.4]
b. 1807
11
Malinda Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.2.5]
b. 30 Jul 1809
11
Olive Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.2.6]
b. 1812
11
Albert Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.2.7]
b. 19 Aug 1815
11
Taylor Baxter Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.2.8]
b. 1817
11
Sarah Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.2.9]
b. 16 May 1820
10
Otis Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.3]
b. 6 Dec 1780 d. 15 Jan 1878
Jedidiah Tilton
b. 4 Oct 1782 d. 2 Apr 1862
11
Mayhew Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.3.1]
b. 1 Sep 1801
Jane Bacon
d. 1850
12
Hiram Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.3.1.1]
b. 1830
12
Caroline Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.3.1.2]
b. 1832
12
Oscar Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.3.1.3]
b. 1834
11
William Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.3.2]
b. 5 Feb 1803 bur. 1871
+
Mary Wilson
Lucy Ann Webber
b. Abt 1811
12
William Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.3.2.1]
b. 1831
12
Sophronia A Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.3.2.2]
b. 1832 d. 21 Aug 1852
12
Josiah Webber Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.3.2.3]
b. 16 Mar 1833 d. 18 Feb 1924 [
=>
]
12
Hannah W Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.3.2.4]
b. 13 Jul 1836 d. 13 May 1911
12
Simon N Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.3.2.5]
b. 1838 d. 1883
+
Betsy Dickerson
b. 1807 d. 1891
11
Huldah Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.3.3]
b. 3 Sep 1804 d. 20 Nov 1843
11
George Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.3.4]
b. 17 Jul 1807
Meribah Taylor
b. Abt 19 Nov 1806 d. 29 Apr 1872
12
Joseph Taylor Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.3.4.1]
b. 21 Jan 1843 d. 1904 [
=>
]
11
Franklin Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.3.5]
b. 25 Nov 1825 d. 2 Jan 1915
Mary Pathena Neal
b. 20 May 1834 d. 25 Dec 1929
12
Otis Mayhew Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.3.5.1]
b. 29 Jun 1869 d. 25 Oct 1922
12
Charles Edward Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.3.5.2]
b. 4 Jan 1872 d. 31 Aug 1964
10
George Washington Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.4]
b. 31 May 1783 d. 27 Jul 1840
Lovinca H Robbins
b. 25 Jun 1786 d. 2 Feb 1853
11
Asa B Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.4.1]
b. 26 Jul 1806 d. 30 Jan 1830
11
Emily R Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.4.2]
b. 29 Oct 1808 d. 17 Oct 1871
+
Lewis Titus Miller
b. 11 Jun 1787 d. 14 Feb 1857
11
Mary Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.4.3]
b. 21 Jan 1811 d. 2 Aug 1865
+
Elias Underwood
b. 1807
11
Charles Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.4.4]
b. 5 Nov 1813 d. Sep 1891
Eliza Jane Densmore
b. 3 Apr 1815 d. 14 Mar 1888
12
Charles Henry Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.4.4.1]
b. 28 Feb 1838 d. 21 May 1909
12
Abbie Jane Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.4.4.2]
b. 17 Jan 1840 d. 8 Jun 1919 [
=>
]
12
Emeline J Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.4.4.3]
b. 22 Nov 1841 d. 26 Apr 1881
12
George Franklin Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.4.4.4]
b. 24 Mar 1843 d. 24 Mar 1844
12
Abial Densmore Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.4.4.5]
b. 7 Aug 1845 d. 7 Nov 1892 [
=>
]
12
Mary Emeline Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.4.4.6]
b. 26 Mar 1847 d. 14 Sep 1873
12
Josiah Franklin Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.4.4.7]
b. 24 Sep 1848 d. 27 Oct 1925 [
=>
]
12
George Frederick Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.4.4.8]
b. 1 Jul 1850 d. 1 Mar 1923 [
=>
]
12
Allen Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.4.4.9]
b. 11 Mar 1852 d. 1 Sep 1921 [
=>
]
12
Amassa Kelly Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.4.4.10]
b. 6 Apr 1854 d. 26 Jan 1933 [
=>
]
12
Luella Blake Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.4.4.11]
b. 25 Jul 1858 d. 19 Jul 1903
11
Elizabeth Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.4.5]
b. 25 Jan 1816 d. May 1873
11
Harriet Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.4.6]
b. 2 Apr 1818
+
Abner Wallace
b. Abt 1814
11
George M Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.4.7]
b. 31 Dec 1820 d. 11 May 1896
Nancy Mull
b. 1828 d. 1851
12
Frederick Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.4.7.1]
b. 18 Jun 1849
Janette Sims
b. 11 Feb 1841 d. 13 Jun 1877
12
Emily Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.4.7.2]
b. 17 Oct 1858 d. 28 Jan 1880
12
George Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.4.7.3]
b. 21 Sep 1860 d. 28 Jun 1928 [
=>
]
12
Louis Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.4.7.4]
b. 22 Dec 1862 d. 25 Jan 1924 [
=>
]
12
Frank Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.4.7.5]
b. 8 Apr 1864 d. 30 Dec 1945 [
=>
]
12
Harry S Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.4.7.6]
b. 1 Oct 1873
11
Lavisa Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.4.8]
b. 4 May 1823 d. 26 Nov 1880
James Skeels
b. 5 Nov 1822 d. 20 Feb 1879
12
Harriet E Skeels
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.4.8.1]
b. 6 Aug 1849 d. 9 Jun 1874
12
Dorr F Skeels
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.4.8.2]
b. 28 Aug 1852 d. 15 May 1879
12
Isaac Skeels
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.4.8.3]
b. 24 Apr 1855 d. 4 Jun 1927 [
=>
]
12
Geroge Edwin Skeels
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.4.8.4]
b. 21 Nov 1857 [
=>
]
12
Arthur Dwight Skeels
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.4.8.5]
b. 2 Jan 1860 d. 8 Sep 1941
12
Earl Sylvester Skeels
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.4.8.6]
b. 18 Dec 1863 d. 8 Nov 1952 [
=>
]
12
Mary C Skeels
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.4.8.7]
b. Feb 1868 d. 1948 [
=>
]
11
Nathan Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.4.9]
b. 19 May 1826
+
Lucetta Tripp
b. Abt 1828
11
David Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.4.10]
b. 19 May 1826
+
Electra Bridges
b. Abt 1828
11
Sarah Ellen Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.4.11]
b. 24 Dec 1829
11
Benjamin Franklin Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.4.12]
b. 27 Aug 1832 d. 12 Mar 1906
Eveline Elizabeth Cole
b. 13 Jul 1840
12
Harriet Eva Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.4.12.1]
b. 3 Nov 1860
12
Henry Benjamin Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.4.12.2]
b. 17 Sep 1866
12
George Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.4.12.3]
b. 11 Jul 1869
12
Martha Alice Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.4.12.4]
b. 15 Feb 1872
12
Sarah Louise Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.4.12.5]
b. 15 Mar 1874
10
Mary Polly Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.5]
b. 16 Aug 1786
+
Caleb Row
b. 26 Oct 1788
10
Oliver Blackinton Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.6]
b. 9 Mar 1789 d. 1874
Lydia Page
b. 1789
11
Henry Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.6.1]
b. 27 Jan 1813
11
Mary Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.6.2]
b. 25 Dec 1815
11
Oliver Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.6.3]
b. 1821
11
Lydia Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.6.4]
b. 1833
11
Martha Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.6.5]
b. 1835
11
Lorenzo Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.6.6]
b. 1838
10
Betsy Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.7]
b. 18 Jun 1792 d. Bef 1876
James Stedman
b. 30 Dec 1789 d. 26 Dec 1858
11
Vernal Richardson Stedman
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.7.1]
b. 12 Aug 1814 d. 8 Mar 1889
Elvira Kaharl
b. 28 Apr 1822 d. 28 Oct 1896
12
Ella Faustina Stedman
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.7.1.1]
b. 27 Mar 1851 d. 9 Oct 1903
12
George H Stedman
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.7.1.2]
[
=>
]
11
George Stedman
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.7.2]
b. 7 Mar 1815 d. 19 Apr 1815
11
Olive B Stedman
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.7.3]
b. 21 Jun 1817
11
James S Stedman
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.7.4]
b. 1 Oct 1820
11
Eliza Ann Stedman
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.7.5]
b. 29 Oct 1822 d. 15 Feb 1823
11
Mary E Stedman
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.7.6]
b. 6 Jul 1829
11
William A Stedman
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.7.7]
b. 25 Mar 1831
10
Anteny Wane Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.8]
b. 20 Jun 1795 d. 1859
Olive S Chase
b. 1799 d. 1884
11
Anthony Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.8.1]
b. 1829
11
John Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.8.2]
b. 1831
11
Maria Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.8.3]
b. 1833
11
William Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.8.4]
b. 1835
11
Adelia F Richardson
[1.1.4.1.3.1.4.4.5.8.5]
b. 1839
8
Sarah Whipple
[1.1.4.1.3.1.4.5]
b. 19 Jun 1737 d. 31 Jul 1812
8
Amey Whipple
[1.1.4.1.3.1.4.6]
b. Abt 1739
8
Abigail Whipple
[1.1.4.1.3.1.4.7]
b. 11 Oct 1740 d. 5 Mar 1820
8
Hope Whipple
[1.1.4.1.3.1.4.8]
b. Abt 1741
+
Anphillis Smith
b. Abt 1660 d. 1715
6
Samuel Whipple, Jr
[1.1.4.1.3.2]
b. 11 Aug 1669 d. 19 Apr 1728
Elizabeth Eddy
b. 3 Aug 1670 d. 14 Mar 1718
7
Alice Whipple
[1.1.4.1.3.2.1]
b. 10 Apr 1693 d. 19 Apr 1728
7
Samuel Whipple
[1.1.4.1.3.2.2]
b. 10 Apr 1693 d. Bef 1695
7
Samuel Whipple, III
[1.1.4.1.3.2.3]
b. 8 Nov 1695 d. Bef Jan 1760
Ruth Card
b. 3 Aug 1700
8
Samuel Whipple, IV
[1.1.4.1.3.2.3.1]
b. 1722 d. 24 Apr 1794
Eunice Mitchell
b. 1717 d. 24 Apr 1794
9
Noah Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1]
b. 10 Jan 1742 d. Abt 17 Jun 1774
Hope Whipple
b. 7 Feb 1740 d. 28 Mar 1829
10
Eunice Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.1]
b. 16 Jun 1764
Comfort Chapman
b. 1760 d. 1786
11
Samuel Chapman
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.1.1]
b. 1778 d. 1805
Abiah Waterhouse
b. Abt 1780 d. 1820
12
Samuel Chapman
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.1.1.1]
b. 30 Jan 1806 d. 16 Oct 1844 [
=>
]
12
Nathan Chapman
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.1.1.2]
b. 27 Mar 1807 d. 28 Nov 1885 [
=>
]
12
Abiah Chapman
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.1.1.3]
b. 18 Oct 1808 d. 8 May 1899 [
=>
]
12
Timothy Chapman
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.1.1.4]
b. Mar 1810
12
Ori Chapman
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.1.1.5]
b. 18 Sep 1813 d. 1898 [
=>
]
11
Betsy Chapman
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.1.2]
b. 1787
Epharim Hawley
b. 1762 d. 24 Aug 1850
11
Noah Whaley
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.1.3]
b. 1794
10
Samuel Stillman Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2]
b. 28 Jun 1766 d. 23 Mar 1843
Hephzibah Gates
b. 24 Dec 1765 d. 3 Nov 1822
11
Hephzibah Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.1]
b. 18 Jun 1790 d. 6 Oct 1849
Daniel Watrous
b. 20 Feb 1793 d. 18 Apr 1879
12
Daniel Watrous
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.1.1]
b. 10 Oct 1814
12
Hepzibah Watrous
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.1.2]
b. 27 Feb 1816 d. 29 Aug 1853
12
Elizabeth Watrous
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.1.3]
b. 7 Jun 1817 d. 6 Nov 1888 [
=>
]
12
Daniel Watrous, Jr
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.1.4]
b. 16 Apr 1819 d. 29 Apr 1886 [
=>
]
12
Fanny Watrous
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.1.5]
b. Feb 1821 d. 27 Nov 1900 [
=>
]
12
Mary Watrous
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.1.6]
b. 9 Jan 1823 d. 27 May 1846
12
James Watrous
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.1.7]
b. 15 Feb 1825 d. 19 Jul 1903 [
=>
]
12
Nathan Watrous
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.1.8]
b. 15 Oct 1827 d. 26 Dec 1827
12
Nathan Watrous
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.1.9]
b. 25 Oct 1828 d. 6 Oct 1890 [
=>
]
12
Sarah Watrous
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.1.10]
b. 26 Feb 1831 d. 11 May 1869 [
=>
]
11
Noah Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.2]
b. 6 Apr 1792 d. 26 Oct 1871
Content Crouch
b. 5 Oct 1794 d. 30 Apr 1835
12
Content Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.2.1]
b. 20 Oct 1814 d. 1875 [
=>
]
12
Noah Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.2.2]
b. 21 Jan 1816 d. 23 Sep 1881 [
=>
]
12
Samuel Gates Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.2.3]
b. 1 Feb 1817 d. 15 Feb 1904 [
=>
]
12
Amos Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.2.4]
b. 12 Aug 1818 d. 7 Aug 1894 [
=>
]
12
William Crouch Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.2.5]
b. 3 Oct 1819 d. 30 Oct 1906 [
=>
]
12
John Bolles Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.2.6]
b. 24 Nov 1820 d. 14 Feb 1870 [
=>
]
12
Lucy Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.2.7]
b. 24 Nov 1820 d. 13 Apr 1894 [
=>
]
12
Phebe Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.2.8]
b. 8 Aug 1822 d. 28 Dec 1850 [
=>
]
12
Hepzibah Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.2.9]
b. 16 Dec 1823 d. 27 Dec 1907 [
=>
]
12
Cyrus Field Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.2.10]
b. 5 Mar 1825 d. 22 Jun 1911 [
=>
]
12
Betsey Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.2.11]
b. 28 Oct 1826 d. 10 Jan 1902 [
=>
]
12
Joseph Francis Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.2.12]
b. 13 Jan 1828 d. 6 Sep 1864
12
David Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.2.13]
b. 8 Jul 1829 d. 29 Jan 1912 [
=>
]
12
Esther Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.2.14]
b. 16 Sep 1830 d. 14 Aug 1905 [
=>
]
12
Zachariah Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.2.15]
b. 2 Feb 1832 d. 26 Mar 1917 [
=>
]
12
Rebecca Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.2.16]
b. 16 Sep 1833 d. 11 Sep 1835
12
Silas Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.2.17]
b. 29 Apr 1835 d. 28 Apr 1836
Christian "Christina" Crouch
b. 23 Oct 1799 d. 5 Jul 1884
12
Miriam Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.2.18]
b. 30 May 1836 d. 3 Jul 1836
12
Rebecca Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.2.19]
b. 26 Jun 1837 d. 31 Jul 1887 [
=>
]
12
Harriet Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.2.20]
b. 12 Feb 1840 d. 20 Mar 1843
12
Margaret Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.2.21]
b. 27 Sep 1842 d. 31 Jan 1914 [
=>
]
12
Charles Plyman Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.2.22]
b. 11 Nov 1845 d. 25 Jan 1919 [
=>
]
11
Jonathan Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.3]
b. 14 Aug 1794 d. 11 Feb 1875
Elizabeth Crouch
b. 26 Jun 1796 d. 26 Nov 1883
12
Elizabeth Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.3.1]
b. 2 Nov 1816 d. 2 Sep 1881 [
=>
]
12
Mary Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.3.2]
b. 15 Jun 1818 d. 7 Oct 1897 [
=>
]
12
Jonathan Crouch Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.3.3]
b. 2 Apr 1821 d. 13 Apr 1885 [
=>
]
12
Abby Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.3.4]
b. 16 May 1823 d. 3 Jan 1859
12
Enoch Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.3.5]
b. 15 Mar 1825 d. 7 Oct 1897 [
=>
]
11
Jabez Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.4]
b. 15 Apr 1796 d. 14 Dec 1870
Mary "Polly" Watrous
b. 12 Jan 1799 d. 3 Jun 1820
12
Jabez Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.4.1]
b. 12 Aug 1818 d. 1 May 1875 [
=>
]
Sarah "Sally" Watrous
b. 16 Nov 1798 d. 13 Sep 1838
12
Timothy Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.4.2]
b. 3 Sep 1821 d. 11 Jan 1892 [
=>
]
12
Sarah "Sally" Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.4.3]
b. 28 Nov 1822 d. 11 Jul 1887 [
=>
]
12
Nathan Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.4.4]
b. 20 Jul 1824 d. 6 Mar 1889 [
=>
]
12
Ira Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.4.5]
b. 9 Apr 1826 d. 29 Apr 1831
12
Mary Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.4.6]
b. 25 Dec 1827 d. 13 Aug 1876 [
=>
]
12
Hannah Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.4.7]
b. 27 Dec 1829 d. 19 Dec 1865 [
=>
]
12
Nancy Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.4.8]
b. 16 Jul 1831 d. Jan 1894
12
Ira Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.4.9]
b. 14 Jan 1834 d. 9 Apr 1903 [
=>
]
12
Hepzibah Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.4.10]
b. 27 Dec 1835 d. Abt 1836
12
Silas Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.4.11]
b. 26 Apr 1837 d. Abt Jul 1837
12
Elisha Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.4.12]
b. 23 Jul 1838 d. Abt Sep 1838
11
Samuel Stillman Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.5]
b. 30 Mar 1798 d. 5 Jun 1836
Harriet Cushman
b. 1794 d. 11 Aug 1836
12
Samuel Stillman Whipple, III
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.5.1]
b. 24 Jun 1820 d. 7 Jun 1848 [
=>
]
12
Harriet Ann Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.5.2]
b. 24 Sep 1821 d. 27 Jul 1869 [
=>
]
12
Paul Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.5.3]
b. 23 Dec 1822 d. 1868 [
=>
]
12
Delight Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.5.4]
b. 29 Apr 1824 d. 3 Feb 1859 [
=>
]
12
John Rogers Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.5.5]
b. 18 Dec 1825 d. 23 Sep 1878
12
Jeduthan Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.5.6]
b. 31 Oct 1827 d. 25 Nov 1920
12
Stephen Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.5.7]
b. 16 Apr 1830 d. 31 May 1830
12
Stephen Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.5.8]
b. 2 Apr 1831 d. 24 May 1832
12
Daniel Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.5.9]
b. 27 Aug 1833 d. 21 May 1839
12
Maria Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.5.10]
b. 28 May 1835 [
=>
]
11
Elizabeth Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.6]
b. 19 Apr 1800 d. 20 Nov 1882
Ichabod Davis
b. 9 Aug 1799 d. 17 Sep 1871
12
Ichabod Davis
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.6.1]
b. 14 Aug 1821 d. 15 Aug 1821
12
Elizabeth "Eliza" Davis
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.6.2]
b. 29 Jul 1822 d. 4 Feb 1904 [
=>
]
12
Ichabod Davis, Jr
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.6.3]
b. 21 Mar 1824 d. 16 Oct 1907 [
=>
]
12
Frances Davis
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.6.4]
b. 15 Mar 1826 d. 28 May 1900 [
=>
]
12
Julia Ann Davis
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.6.5]
b. 28 Feb 1828 d. 16 Sep 1907 [
=>
]
12
Delia Content Davis
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.6.6]
b. 20 Jan 1830 d. 21 May 1893 [
=>
]
12
Hannah Melissa Davis
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.6.7]
b. 15 Dec 1832 d. 26 Feb 1911 [
=>
]
12
Lucy Esther Davis
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.6.8]
b. 1 Apr 1834 d. 31 Jan 1907 [
=>
]
12
Ellen Davis
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.6.9]
b. 31 Jan 1835 d. 27 Nov 1860 [
=>
]
12
Nancy Jane Davis
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.6.10]
b. 8 Dec 1837 d. 20 Nov 1894 [
=>
]
12
Mary Davis
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.6.11]
b. 8 Dec 1839 d. 30 Mar 1931 [
=>
]
12
Emily Davis
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.2.6.12]
b. 20 Nov 1843 d. 31 May 1890 [
=>
]
10
Jonathan Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.3]
b. 14 Aug 1769 d. Jan 1795
Hannah Stark
b. 1771 d. 30 Sep 1827
11
Daniel Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.3.1]
b. 22 Jun 1794 d. 8 Feb 1835
Christian "Christina" Crouch
b. 23 Oct 1799 d. 5 Jul 1884
12
Daniel Whipple, Jr
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.3.1.1]
b. 7 Oct 1817 d. 10 Nov 1885 [
=>
]
12
Christian Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.3.1.2]
b. 12 Jan 1819 d. 10 Feb 1888
12
Mary Ann Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.3.1.3]
b. 1 Jul 1820 d. 6 Mar 1894 [
=>
]
12
Henry Horace Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.3.1.4]
b. 31 Oct 1821 d. 2 Mar 1909 [
=>
]
12
Sally Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.3.1.5]
b. 4 Dec 1823 d. 9 Aug 1900 [
=>
]
12
Jonathan Crouch Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.3.1.6]
b. 21 Jul 1825 d. 25 Jun 1900 [
=>
]
12
Hannah Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.3.1.7]
b. 30 Jun 1827 d. 30 Sep 1827
12
Hannah Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.3.1.8]
b. 1 May 1829 d. 5 May 1856 [
=>
]
12
Miriam Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.3.1.9]
b. 26 Jul 1831 d. 10 Jan 1836
12
Content Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.3.1.10]
b. 22 Oct 1833 d. 11 Apr 1838
10
Noah Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.4]
b. 9 Aug 1771
+
Peggy Dunbar
b. 1775
10
Silas Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.5]
b. 25 Jul 1773 d. 1835
Ester Watrous
b. 1772 d. 1853
11
Esther Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.5.1]
b. 16 Apr 1795 d. 4 Oct 1847
Luther Geer
b. 17 Feb 1793 d. 21 Aug 1871
12
Esther Caroline Geer
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.5.1.1]
b. 1 Nov 1814 d. Aft 1876 [
=>
]
12
Luther Avery Geer
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.5.1.2]
b. 15 Mar 1817 d. 27 Jun 1881 [
=>
]
12
Solomon Geer
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.5.1.3]
b. 22 Sep 1819 d. 14 Jul 1892 [
=>
]
12
Silas Whipple Geer
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.5.1.4]
b. 12 Jan 1822 d. 26 Apr 1899 [
=>
]
12
Lucinda Geer
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.5.1.5]
b. 12 Oct 1824 [
=>
]
12
Hiram P Geer
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.5.1.6]
b. 27 Mar 1827
12
Jacob Geer
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.5.1.7]
b. 15 Aug 1829 d. Sep 1845
12
Henrietta Geer
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.5.1.8]
b. 28 Nov 1830 [
=>
]
12
Eunice Ophelia Geer
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.5.1.9]
b. 4 Nov 1838 d. 24 Feb 1917 [
=>
]
11
Hope Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.5.2]
b. 1797
John "John Smith" Mairs
b. 1795 d. 13 May 1883
12
Hope Ardelia Smith
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.5.2.1]
b. 16 Jun 1826 d. 28 Dec 1896 [
=>
]
12
Dorothy Carolina Smith
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.5.2.2]
b. 18 Mar 1828 d. 30 Aug 1917 [
=>
]
12
John Alden Smith
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.5.2.3]
b. Abt 1829
12
Margaret Smith
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.5.2.4]
b. Abt 1830
12
Charles Frederick Smith
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.5.2.5]
b. Abt 1831 d. 30 Aug 1917
12
Elsie Smith
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.5.2.6]
b. Abt 1832
12
Eliza Smith
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.5.2.7]
b. Abt 1833
12
John Reynard Smith
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.5.2.8]
b. Abt 1834
12
Henry Schleiman Smith
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.5.2.9]
b. 1836 d. 30 Dec 1860
12
Esther Amelia Smith
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.5.2.10]
b. 1 May 1839 d. 28 Apr 1930 [
=>
]
11
Content Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.5.3]
b. 18 Jun 1798 d. 23 Jun 1820
+
Ichabod Davis
b. 9 Aug 1799 d. 17 Sep 1871
11
Ellis Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.5.4]
b. 1800 d. 1820
11
Hannah Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.5.5]
b. 1802 d. 10 Jul 1825
Thomas Geer
b. 6 Jan 1801 d. 15 Nov 1866
12
Hannah Cordelia Geer
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.5.5.1]
b. 11 Aug 1823 d. 10 Sep 1904 [
=>
]
12
Lucy Ann Geer
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.5.5.2]
b. 5 Jul 1825 d. 14 Feb 1884 [
=>
]
11
Eunice Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.5.6]
b. 14 Feb 1805 d. 7 Nov 1829
John Crouch, Jr
b. 19 May 1800 d. Mar 1868
12
Eunice Crouch
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.5.6.1]
b. 7 Nov 1829 d. 9 Feb 1857
12
Silas Crouch
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.5.6.2]
b. 7 Nov 1829 d. 10 Jan 1830
11
Thankful Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.5.7]
b. 24 Sep 1806 d. 26 May 1894
Thomas Geer
b. 6 Jan 1801 d. 15 Nov 1866
12
Thankful Amela Geer
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.5.7.1]
b. 18 Feb 1827 d. 11 Dec 1895 [
=>
]
12
Lucy Ann Geer
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.5.7.2]
b. 18 Feb 1827
12
Eliza Geer
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.5.7.3]
b. 11 Jun 1833 d. 24 Aug 1902 [
=>
]
12
Abby Jane Geer
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.5.7.4]
b. Abt 1835 d. Abt 1836
12
Emily Jane Geer
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.5.7.5]
b. 16 Jun 1836 d. 25 Feb 1875 [
=>
]
12
Abby Jane Geer
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.5.7.6]
b. 1838 d. 1839
12
Lucinda Geer
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.5.7.7]
b. 14 Aug 1840 d. 7 Aug 1903 [
=>
]
12
Thomas Pierce Geer
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.5.7.8]
b. 11 Jun 1843 d. 26 Nov 1900 [
=>
]
12
Mary Gibson Geer
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.5.7.9]
b. 21 Jul 1847 d. 17 Dec 1900 [
=>
]
12
Abby Jane Geer
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.5.7.10]
b. Abt 1851
11
Silas Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.5.8]
b. Abt 1807
11
Abigail Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.5.9]
b. Apr 1810 d. Dec 1810
11
Timothy Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.5.10]
b. Feb 1811 d. Apr 1811
11
Alice Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.5.11]
b. 1814 d. 12 Feb 1891
Lyman D Moffatt
b. 1813
12
Elsie Ann Moffatt
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.5.11.1]
b. 1836 [
=>
]
12
Lyman Ray Moffatt
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.5.11.2]
b. 22 Dec 1837 d. 17 Aug 1885 [
=>
]
12
Silas Whipple Moffatt
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.5.11.3]
b. 1841 [
=>
]
12
Anetta Moffatt
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.5.11.4]
b. 1846 [
=>
]
12
Samuel W Moffatt
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.5.11.5]
b. 1844
12
John D Moffatt
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.5.11.6]
b. 25 Sep 1847
12
Eva I Moffatt
[1.1.4.1.3.2.3.1.1.5.11.7]
b. 1849 d. 8 Oct 1919 [
=>
]
9
Lucretia Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.2]
b. 18 Nov 1744 d. 30 Jul 1814
Daniel Kennedy
b. 1743 d. 28 Jan 1792
10
Mary Kennedy
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.1]
b. 10 Sep 1765
Asahel S Partelow
b. 31 May 1767 d. 12 Aug 1825
11
Rosanna Partelow
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.1.1]
b. 22 Dec 1788 d. 7 Mar 1790
11
Wealthy Partelow
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.1.2]
b. 10 Feb 1791 d. 30 Apr 1839
Ethan Allen
b. Nov 1778 d. 23 Jul 1867
12
Latham H Allen
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.1.2.1]
b. 6 May 1822 d. 30 Apr 1841
12
Wealthy Partelo Allen
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.1.2.2]
b. 20 Jul 1827 d. 25 Jul 1906 [
=>
]
11
Deborah Partelow
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.1.3]
b. 25 Apr 1793
11
Welcome Jonas Partelow
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.1.4]
b. 6 Jul 1795 d. 1863
Rhoda Phinney
b. 1801 d. 1865
12
Welcome Phineas Partello
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.1.4.1]
b. 22 Oct 1818 d. 5 Aug 1895 [
=>
]
12
Charles C Partello
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.1.4.2]
b. 1833
12
Phedora Elizabeth Partello
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.1.4.3]
b. 17 Jun 1835 d. 3 Aug 1874 [
=>
]
12
Dwight Delos Partello
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.1.4.4]
b. 1838 [
=>
]
12
Henry H Partello
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.1.4.5]
b. 1841 d. 1864
12
Albert Partello
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.1.4.6]
b. Abt 1843 d. 1857
12
Asenath E Partello
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.1.4.7]
b. 1846 d. 13 Dec 1891 [
=>
]
10
Euince Kennedy
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.2]
b. Abt 1766 d. 6 Oct 1849
Ephraim Keigwin
b. 26 Sep 1766 d. 13 Mar 1841
11
Daniel Kennedy Keigwin
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.2.1]
b. 12 Jun 1790
11
Sarah Keigwin
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.2.2]
b. 8 Jun 1792
11
Betsey Keigwin
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.2.3]
b. 28 Jul 1794 d. 11 Jun 1867
William Apley
b. 1789 d. 15 Apr 1843
12
William W Apley
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.2.3.1]
b. 1817 d. 21 Apr 1863
12
Elias Parks Apley
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.2.3.2]
b. 17 Jun 1818
12
Lester Bill Apley
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.2.3.3]
b. 27 Jun 1822 d. 3 Jan 1883 [
=>
]
12
Mary Ann Apley
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.2.3.4]
b. 1824 [
=>
]
12
John Apley
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.2.3.5]
b. 1826 d. 11 Apr 1838
12
George W Apley
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.2.3.6]
b. 25 Apr 1828 d. 29 Sep 1914
12
Louisa Apley
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.2.3.7]
b. 1830
12
Dwight Apley
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.2.3.8]
b. 14 Aug 1833 d. 10 Dec 1907 [
=>
]
12
Andrew Apley
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.2.3.9]
b. 1834 d. 1871 [
=>
]
12
Henry Apley
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.2.3.10]
b. 1838 d. 9 Jan 1864
11
James Keigwin
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.2.4]
b. 17 May 1796 d. 1861
Janette de Christtians
b. Abt 1802
12
William Keigwin
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.2.4.1]
b. 15 Apr 1821
12
Harriet Keigwin
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.2.4.2]
b. 27 Nov 1822
12
Mary Jane Keigwin
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.2.4.3]
b. 1824 [
=>
]
12
Eliza Ann Keigwin
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.2.4.4]
b. 13 Nov 1825 d. 13 May 1852 [
=>
]
12
Rebecca Keigwin
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.2.4.5]
b. 1827 d. 1906 [
=>
]
12
James Keigwin
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.2.4.6]
b. 18 Oct 1829 [
=>
]
12
Theodore Keigwin
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.2.4.7]
b. 23 Apr 1834
12
Henry Keigwin
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.2.4.8]
b. 5 Jan 1836
12
Martha Keigwin
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.2.4.9]
b. 1 Mar 1838 [
=>
]
12
Albert Newton Keigwin
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.2.4.10]
b. 20 Feb 1840 d. 11 Mar 1920 [
=>
]
12
Susan Keigwin
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.2.4.11]
b. 20 Jun 1842
12
Emma Keigwin
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.2.4.12]
b. 26 Jan 1845
11
Ephraim Keigwin
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.2.5]
b. 21 Jun 1800
11
Eunice Keigwin
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.2.6]
b. 1 Nov 1802
11
Harriet Keigwin
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.2.7]
b. 27 Mar 1805
11
Amos Treat Keigwin
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.2.8]
b. 22 Mar 1807 d. 27 Sep 1898
Alice Kennedy Larkam
b. 19 Apr 1803 d. 30 Jan 1866
12
Alice L Keigwin
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.2.8.1]
b. 1830 d. 18 Jan 1844
12
Cornelia Alice Keigwin
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.2.8.2]
b. 22 Apr 1831 d. 14 Oct 1873 [
=>
]
12
Amos J Keigwin
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.2.8.3]
b. 22 Dec 1835 d. 22 Mar 1907 [
=>
]
12
Horace H Keigwin
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.2.8.4]
b. 11 Dec 1838 d. 8 Apr 1926 [
=>
]
12
Caroline Keigwin
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.2.8.5]
b. 1840 d. 5 Aug 1850
12
Frank G Keigwin
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.2.8.6]
b. Feb 1845 d. 25 Jan 1846
11
Eliza R Keigwin
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.2.9]
b. 25 Sep 1809 d. 10 Oct 1809
11
Ezra Whipple Keigwin
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.2.10]
b. 14 Nov 1810 d. 15 Dec 1889
Catharine Delia Howe
b. 3 Nov 1813 d. 10 Apr 1904
12
John H Keigwin
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.2.10.1]
b. 23 Nov 1833
12
George Sperry Keigwin
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.2.10.2]
b. 23 Apr 1835 d. 14 Feb 1839
12
Dwight Ripley Keigwin
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.2.10.3]
b. 16 Jul 1837 d. 1 Dec 1889 [
=>
]
12
George Westly Keigwin
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.2.10.4]
b. 13 Feb 1843
10
Ann Kennedy
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.3]
b. 17 Nov 1769
10
Lucretia Whipple Kennedy
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.4]
b. 28 Apr 1773 d. 22 Sep 1845
Robert Harris
b. 12 Dec 1766 d. 22 Jul 1826
11
Lucretia Harris
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.4.1]
b. 23 Oct 1789 d. 28 Nov 1789
11
Dorotha Rude Harris
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.4.2]
b. 15 Apr 1791 d. 5 Jul 1863
John Keeney
b. 29 Apr 1786 d. 4 Apr 1839
12
Fanny Lucretia Keeney
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.4.2.1]
b. 29 May 1810 d. 10 Sep 1890 [
=>
]
12
Nelson Keeney
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.4.2.2]
b. Abt 1812
12
John Robert Keeney
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.4.2.3]
b. 22 Jun 1812 d. 23 Apr 1875 [
=>
]
12
Salenda Keeney
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.4.2.4]
b. 2 Apr 1814 d. 1895
12
William Jonathan Keeney
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.4.2.5]
b. 27 Mar 1816 d. 9 Jul 1889 [
=>
]
12
Harris Keeney
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.4.2.6]
b. Abt 1818
12
Ira Keeney
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.4.2.7]
b. Abt 1820
12
Hiram B Keeney
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.4.2.8]
b. 26 Apr 1820 d. 12 Oct 1866
12
Esther Booth Keeney
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.4.2.9]
b. 5 Aug 1822 d. 1841
12
Ester Keeney
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.4.2.10]
b. Abt 1824
12
Alfred Keeney
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.4.2.11]
b. 12 Mar 1830 d. 18 Feb 1903
12
Helen Amelia Keeney
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.4.2.12]
b. Jun 1835 d. 12 Mar 1906
11
Robert Harris, Jr
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.4.3]
b. 5 May 1793 d. 18 Dec 1865
11
Alice Harris
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.4.4]
b. 16 Jun 1795 d. 6 Nov 1884
11
Daniel Kennedy Harris
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.4.5]
b. 12 Dec 1797 d. 3 Jun 1879
11
James Hiram Harris
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.4.6]
b. 31 Mar 1800 d. Abt 1818
11
Jacob Rude Harris
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.4.7]
b. Abt 1802 d. 2 Jun 1885
11
Lucretia Whipple Harris
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.4.8]
b. 5 Mar 1804 d. Bef 1821
11
Cyntha Lydia Hill Harris
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.4.9]
b. 14 Apr 1806 d. 30 Nov 1863
11
Fannie M Harris
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.4.10]
b. 1808 d. 1892
11
Josiah John Nelson Harris
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.4.11]
b. 13 Mar 1811 d. 17 Aug 1897
11
Mary Zilpha Ann Harris
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.4.12]
b. 1 Jun 1813 d. 18 Aug 1815
11
Miles Wesley Harris
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.4.13]
b. 12 Mar 1818 d. 19 Aug 1898
10
Alice Kennedy
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.5]
b. 31 May 1775
10
John Kennedy
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.6]
b. 1777 d. 22 Jun 1851
10
Elisabeth Kennedy
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.7]
b. 1779 d. 25 Aug 1814
Lot Larkham
b. 14 Mar 1774 d. 22 May 1847
11
Daniel Kennedy Larkham
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.7.1]
b. 8 Mar 1797
11
Erastus Renssalear Larkham
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.7.2]
b. 5 Jul 1801
11
Alice Kennedy Larkam
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.7.3]
b. 19 Apr 1803 d. 30 Jan 1866
Amos Treat Keigwin
b. 22 Mar 1807 d. 27 Sep 1898
12
Alice L Keigwin
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.7.3.1]
b. 1830 d. 18 Jan 1844
12
Cornelia Alice Keigwin
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.7.3.2]
b. 22 Apr 1831 d. 14 Oct 1873 [
=>
]
12
Amos J Keigwin
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.7.3.3]
b. 22 Dec 1835 d. 22 Mar 1907 [
=>
]
12
Horace H Keigwin
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.7.3.4]
b. 11 Dec 1838 d. 8 Apr 1926 [
=>
]
12
Caroline Keigwin
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.7.3.5]
b. 1840 d. 5 Aug 1850
12
Frank G Keigwin
[1.1.4.1.3.2.3.1.2.7.3.6]
b. Feb 1845 d. 25 Jan 1846
9
Joseph Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.3]
b. 12 Dec 1748 d. 31 Aug 1799
Jennet Campbell
b. Abt 1752 d. 17 Oct 1840
10
Mary Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.3.1]
b. 4 Apr 1774 d. 22 Dec 1842
Jared Gallup
b. 22 Nov 1767 d. 28 Oct 1828
11
Joseph Henry Gallup
[1.1.4.1.3.2.3.1.3.1.1]
b. 14 Sep 1806 d. 22 May 1861
Sarah Maria Parish
b. 7 May 1808 d. 20 May 1852
12
Sarah Josephine Gallup
[1.1.4.1.3.2.3.1.3.1.1.1]
b. 8 Jul 1837 [
=>
]
11
Henry Joseph Gallup
[1.1.4.1.3.2.3.1.3.1.2]
b. 1 Feb 1810 d. 1 Nov 1882
Elizabeth Fox
b. 22 Apr 1824 d. 2 Sep 1901
12
Henry Jared Gallup
[1.1.4.1.3.2.3.1.3.1.2.1]
b. 11 Mar 1851 d. 26 Sep 1921 [
=>
]
12
Mary Elizabeth Gallup
[1.1.4.1.3.2.3.1.3.1.2.2]
b. 26 Jun 1855 d. 12 Dec 1920
12
William Clarence Gallup
[1.1.4.1.3.2.3.1.3.1.2.3]
b. 7 Apr 1858 d. 18 Apr 1915 [
=>
]
12
John Mason Gallup
[1.1.4.1.3.2.3.1.3.1.2.4]
b. 31 May 1861 d. 31 Aug 1865
9
Jonathan Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.4]
b. 26 Apr 1750 d. Abt 1828
+
Lucretia Perone
b. 1752
9
Peronne Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.5]
b. 5 Apr 1752 d. 10 Sep 1817
Jonathan Church
b. 7 Apr 1747 d. 23 Dec 1827
10
Daniel Whipple Church
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.1]
b. 10 May 1772 d. 7 Jan 1857
Dorothy "Dolly" Wheeler
b. 1 Aug 1777 d. 18 Sep 1822
11
Horace Howard Church
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.1.1]
b. 25 Apr 1797 d. 11 Nov 1802
11
Abijah Wheeler Church
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.1.2]
b. 31 Aug 1798 d. 1875
Almira Clara Rowe
b. Abt 1800
12
Joseph Addison Church
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.1.2.1]
b. 1824 d. 11 Nov 1915 [
=>
]
12
Robert B Church
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.1.2.2]
b. 1826
12
Seth Rowe Church
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.1.2.3]
b. 1828 d. 1895 [
=>
]
12
Emily Clarke Church
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.1.2.4]
b. 1830 d. 1875 [
=>
]
12
Danile Whipple Church
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.1.2.5]
b. 1832 d. 1834
12
Edmund L Church
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.1.2.6]
b. 1834 d. 1835
12
Edmund Wheeler Church
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.1.2.7]
b. 1838 d. 1846
12
Mary Elmira Church
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.1.2.8]
b. 1845 d. 1845
11
Royal Tyler Church
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.1.3]
b. 26 Aug 1800 d. 1872
Eleanor Howard
b. 1810 d. 25 Apr 1903
12
Julia Church
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.1.3.1]
b. 1834 d. 8 May 1872 [
=>
]
11
Peronius Whipple Church
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.1.4]
b. 3 Sep 1802 d. 25 May 1840
Sarah Turnbull
b. 1806 d. 25 Aug 1863
12
Sarah P Church
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.1.4.1]
b. 1827
11
Dorothy "Dolly" Church
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.1.5]
b. 21 Jan 1804 d. 1841
+
Thomas S Hale
11
Mary Howard Church
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.1.6]
b. 19 Jan 1805 d. 11 Jan 1831
+
Ralph D Wallace
11
James Howard Church
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.1.7]
b. 30 May 1807 d. 1881
Eliza Clark
b. 1807 d. 1836
12
Mariah Church
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.1.7.1]
b. 1812 d. 1827
12
Lewis Howard Church
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.1.7.2]
11
Daniel Church
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.1.8]
b. 17 Sep 1809 d. 1883
+
Harriet Wheeler
11
Jonathan Lewis Church
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.1.9]
b. 26 Sep 1811
11
Peronne C Church
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.1.10]
b. 14 Aug 1813 d. 1902
Thomas S Hall
c. 26 Mar 1797
12
William C Hall
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.1.10.1]
b. 1835
12
Henry H Hall
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.1.10.2]
b. 1837
12
Charles Hall
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.1.10.3]
b. 1843 [
=>
]
12
George Hall
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.1.10.4]
b. 1846
12
Claire Hall
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.1.10.5]
b. Jun 1850 d. 1923 [
=>
]
12
Robert Hall
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.1.10.6]
b. 29 Oct 1851 d. 1941 [
=>
]
11
Ezra Church
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.1.11]
b. 24 Nov 1815 d. 16 Jan 1818
11
Artemus Maynard Church
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.1.12]
b. 27 Feb 1820 d. 24 Jun 1855
10
Eunice Church
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.2]
b. 14 Aug 1773
Zimri Smith
b. Abt 1770
11
Urania Smith
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.2.1]
b. 9 Jul 1774
11
Samuel B Smith
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.2.2]
b. Abt 1793
11
Daniel Church Smith
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.2.3]
b. 21 Dec 1795
10
Lucy Church
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.3]
b. 19 Jun 1776
+
Israel Porter
b. 27 Nov 1771 d. 16 Sep 1836
10
Ezra Church
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.4]
b. 7 May 1778 d. Abt 1859
Mercy Farr
b. 1778
11
Roxana Church
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.4.1]
b. Abt 1806 d. 14 Jun 1890
John Rial Sterling
b. 20 May 1802 d. 2 May 1867
12
Howard Sterling
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.4.1.1]
b. 1828 d. 1917 [
=>
]
12
Bradford Sterling
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.4.1.2]
b. Abt 1832 d. 7 Dec 1901
12
Frances Elizabeth Sterling
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.4.1.3]
b. 2 Apr 1835 d. 13 Feb 1844
12
James Lloyd Sterling
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.4.1.4]
b. 4 Jun 1838 d. 10 Nov 1905
12
Jane S Sterling
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.4.1.5]
b. 18 Sep 1840
12
Jennie Sterling
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.4.1.6]
b. Abt 1842
12
Ella Therese Sterling
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.4.1.7]
b. 15 Oct 1848 d. 27 Sep 1937 [
=>
]
12
Julia Anna Sterling
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.4.1.8]
b. 1 Jan 1852 d. Feb 1889 [
=>
]
10
Cyrus Church
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.5]
b. 19 Feb 1782 d. 26 Dec 1868
10
Clarissa Church
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.6]
b. 7 Mar 1784 d. Abt 1870
10
Jonathan Church
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.7]
b. 27 Jul 1786 d. 12 Sep 1788
10
Horace Church
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.8]
b. 1 Oct 1788 d. 2 Jul 1792
10
Urania Church
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.9]
b. 18 Feb 1792 d. 12 Nov 1792
10
Eleanor Church
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.10]
b. 10 Jan 1780 d. Oct 1828
James W Howard
b. 8 Oct 1778 d. 18 Jul 1860
11
James Corydon Howard
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.10.1]
b. 25 Sep 1804 d. 18 Oct 1880
Sophronia Porter
b. 30 May 1809 d. 1854
12
James Porter Howard
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.10.1.1]
b. 6 Dec 1829 d. 2 Apr 1912 [
=>
]
12
John Howard
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.10.1.2]
b. 1831
12
Ellen Howard
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.10.1.3]
b. 1832
12
Dean Howard
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.10.1.4]
b. 1834
12
Perone Whipple Howard
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.10.1.5]
b. 1836 d. 1875 [
=>
]
12
George Howard
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.10.1.6]
b. 1838
12
Sophronia Howard
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.10.1.7]
b. 1842
12
Ann Howard
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.10.1.8]
b. 1844
12
Frank Howard
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.10.1.9]
b. 1848
12
Child Howard
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.10.1.10]
b. 1849
12
Arthur Dean Howard
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.10.1.11]
b. 15 Oct 1854 d. 12 Dec 1943 [
=>
]
11
Dean S Howard
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.10.2]
b. 29 Jul 1806
Anna Amelia Lyon
b. 11 Oct 1812 d. 1 Aug 1873
12
Anne Howard
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.10.2.1]
b. 1835
12
Lyman D Howard
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.10.2.2]
b. Abt 1838 [
=>
]
11
Eleanor Howard
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.10.3]
b. 1810 d. 25 Apr 1903
Royal Tyler Church
b. 26 Aug 1800 d. 1872
12
Julia Church
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.10.3.1]
b. 1834 d. 8 May 1872 [
=>
]
11
Elizabeth Barrett Howard
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.10.4]
b. 4 Jan 1816 d. 15 Oct 1886
Thomas Turnbull
b. 19 Mar 1797 d. 26 Jul 1882
12
Eleanor Church Turnbull
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.10.4.1]
b. 14 Aug 1834 d. 18 Jun 1899
12
James H Turnbull
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.10.4.2]
b. 2 Mar 1836 d. 12 Jan 1898
12
Thomas Peronius Turnbull
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.10.4.3]
b. 30 Oct 1837 d. 23 Jun 1900 [
=>
]
12
Sarah Elizabeth Turnbull
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.10.4.4]
b. 6 Dec 1840 d. 11 Aug 1914
12
Corydon Maxwell Turnbull
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.10.4.5]
b. 6 Feb 1844 d. 19 May 1929 [
=>
]
12
Mary E Turnbull
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.10.4.6]
b. 25 Apr 1846 d. 8 Jun 1872
12
Margaret S Turnbull
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.10.4.7]
b. 26 Apr 1852 d. 30 May 1898 [
=>
]
12
Dean Samuel Turnbull
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.10.4.8]
b. 9 Dec 1853 d. 1 Dec 1896 [
=>
]
12
Anna Amelia Lyon Turnbull
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.10.4.9]
b. Apr 1858 d. 23 Jun 1932 [
=>
]
11
Lucy P Howard
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.10.5]
b. 11 Apr 1818 d. 17 Oct 1819
11
Frederick M Howard
[1.1.4.1.3.2.3.1.5.10.6]
b. 11 Apr 1818 d. 13 Oct 1819
9
Alice Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.6]
b. 5 Jan 1754
+
Silas Smith
b. 1750
9
Elizabeth Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.7]
b. 8 Jun 1756
+
Benjamin Church
b. 20 May 1751
9
Nathan Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8]
b. 2 Apr 1759 d. 28 Jul 1810
Rachel Campbell
b. 1760 d. Aft 1822
10
Nancy Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.1]
b. Abt 1782
+
John Bowman
b. 1782
10
Charissa Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.2]
b. 1788 d. 1859
Chandler Ward
b. 16 Jul 1786 d. 15 May 1861
11
Bernard Ward
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.2.1]
b. 1807
11
August B Ward
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.2.2]
b. 20 Apr 1811 d. 10 Jan 1885
Mary Ann Whipple
b. 5 Nov 1812 d. 26 Jun 1899
12
Emily Ward
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.2.2.1]
b. 4 May 1832 d. 25 Jul 1917 [
=>
]
12
Alfred Ward
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.2.2.2]
b. 2 Oct 1833 d. Bef 1880
12
Chandler Ward
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.2.2.3]
b. 28 Nov 1835 d. 20 May 1914 [
=>
]
12
Hiram Ward
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.2.2.4]
b. 22 Feb 1838 d. 17 Nov 1903 [
=>
]
12
Mary Ward
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.2.2.5]
b. 15 Dec 1839 d. 25 Jan 1883 [
=>
]
12
Minerva Ward
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.2.2.6]
b. 20 Apr 1841 d. 30 Jan 1919 [
=>
]
12
Norman Perry Ward
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.2.2.7]
b. 12 Jun 1843
12
Ellen Ward
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.2.2.8]
b. 3 Feb 1845 d. 26 Sep 1864 [
=>
]
12
Miner Ward
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.2.2.9]
b. 12 Oct 1846 d. 8 Apr 1910 [
=>
]
12
George Jackson Ward
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.2.2.10]
b. 4 Sep 1848 d. Aft 1925 [
=>
]
12
Miron Ward
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.2.2.11]
b. 13 Oct 1851 d. 1856
12
Heman Liscom Ward
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.2.2.12]
b. 15 Sep 1853 d. 26 Dec 1903 [
=>
]
11
Alcenas Ward
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.2.3]
b. 14 Mar 1813 d. 2 Aug 1890
Ann Elisa Dillon
b. 6 Oct 1819 d. 31 Mar 1899
12
William Ward
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.2.3.1]
b. 1836 d. 24 Oct 1892 [
=>
]
12
Maria Scott Ward
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.2.3.2]
b. 1837 d. 28 Jun 1913 [
=>
]
12
Byron Chandler Ward
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.2.3.3]
b. 28 Nov 1838 d. 18 Jun 1922 [
=>
]
12
William Ward
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.2.3.4]
b. 20 Apr 1840 d. 24 Oct 1892
12
Eliza Hannah Ward
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.2.3.5]
b. 26 Aug 1844 d. 6 Jun 1906 [
=>
]
12
Chandler A Ward
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.2.3.6]
b. 2 Oct 1845 [
=>
]
12
Charlotte Sophia Ward
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.2.3.7]
b. 12 Aug 1851 d. 1900 [
=>
]
12
John Ward
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.2.3.8]
b. Abt 1853 d. 1881
12
George Ward
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.2.3.9]
b. Abt 1855
12
Chauncey Ward
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.2.3.10]
b. Abt 1857
12
Arthur Ward
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.2.3.11]
b. 22 May 1857 d. Apr 1930 [
=>
]
12
Samuel Denison Ward
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.2.3.12]
b. 23 Dec 1863 d. 1 Apr 1947 [
=>
]
11
Whipple Ward
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.2.4]
b. Abt 1815 d. Bef 1868
Mary M Dow
b. 1816 d. Feb 1842
12
George Washington Ward
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.2.4.1]
b. Abt 1842 d. 8 Jan 1915 [
=>
]
11
Harvey Ward
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.2.5]
b. 16 Jan 1815 d. 2 Aug 1890
Louisa Lane
b. 5 Jun 1812 d. 10 Jun 1840
12
Byron Chandler Ward
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.2.5.1]
b. 28 Nov 1838 d. 18 Jun 1922 [
=>
]
12
Sarah Louisa Ward
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.2.5.2]
b. 2 May 1840 d. 24 May 1903 [
=>
]
Eliza Reed
b. Abt 1820 d. 12 Mar 1876
12
Almira Eliza Ward
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.2.5.3]
b. 10 Jan 1843 d. 20 Jan 1906 [
=>
]
12
Edwin R Ward
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.2.5.4]
b. 25 Oct 1845 d. 8 May 1906
12
Florence Levina Ward
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.2.5.5]
b. 2 Jun 1851 d. 23 Oct 1923 [
=>
]
11
Candace Ward
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.2.6]
b. 1822 d. 1880
Nathan Whipple
b. 13 Nov 1818 d. 17 Nov 1863
12
Rachel Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.2.6.1]
b. 1843 d. 1890
12
Nancy Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.2.6.2]
b. 1845 d. 1907
12
David Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.2.6.3]
b. 9 Mar 1855 d. 1938 [
=>
]
12
Bernard Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.2.6.4]
b. 5 Oct 1858 d. 12 Nov 1927 [
=>
]
12
Isaac E Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.2.6.5]
b. Abt 1859
12
William Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.2.6.6]
b. Abt 1859 d. 1916 [
=>
]
12
Nathan Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.2.6.7]
b. 1862
10
Isaac Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3]
b. 3 Mar 1786 d. 5 Dec 1825
Rachel Lanning
b. 12 Jul 1789 d. 19 Apr 1869
11
Anna Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.1]
b. 13 Sep 1807 d. 15 Sep 1807
11
Jonathan Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.2]
b. 24 Aug 1808 d. 31 Jan 1874
Armina Clarke
b. 1812 d. Aft 1850
12
Abner Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.2.1]
b. 1838 d. Aft 1850
12
Hannah Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.2.2]
b. 1840 d. Aft 1850
12
Wallace L. Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.2.3]
b. 1842 d. Aft 1850
12
I Lanning Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.2.4]
b. Sep 1843 d. 1926 [
=>
]
12
Irena Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.2.5]
b. 1849 d. Aft 1850
11
Clarissa Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.3]
b. 10 Aug 1810 d. 15 Jul 1815
11
Mary Ann Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.4]
b. 5 Nov 1812 d. 26 Jun 1899
August B Ward
b. 20 Apr 1811 d. 10 Jan 1885
12
Emily Ward
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.4.1]
b. 4 May 1832 d. 25 Jul 1917 [
=>
]
12
Alfred Ward
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.4.2]
b. 2 Oct 1833 d. Bef 1880
12
Chandler Ward
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.4.3]
b. 28 Nov 1835 d. 20 May 1914 [
=>
]
12
Hiram Ward
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.4.4]
b. 22 Feb 1838 d. 17 Nov 1903 [
=>
]
12
Mary Ward
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.4.5]
b. 15 Dec 1839 d. 25 Jan 1883 [
=>
]
12
Minerva Ward
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.4.6]
b. 20 Apr 1841 d. 30 Jan 1919 [
=>
]
12
Norman Perry Ward
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.4.7]
b. 12 Jun 1843
12
Ellen Ward
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.4.8]
b. 3 Feb 1845 d. 26 Sep 1864 [
=>
]
12
Miner Ward
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.4.9]
b. 12 Oct 1846 d. 8 Apr 1910 [
=>
]
12
George Jackson Ward
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.4.10]
b. 4 Sep 1848 d. Aft 1925 [
=>
]
12
Miron Ward
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.4.11]
b. 13 Oct 1851 d. 1856
12
Heman Liscom Ward
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.4.12]
b. 15 Sep 1853 d. 26 Dec 1903 [
=>
]
11
Rachel Lanning Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.5]
b. 12 Oct 1814 d. 5 Feb 1855
Isaac W Vannest
b. 4 Feb 1814 d. 13 Sep 1881
12
Lydia S Vannest
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.5.1]
b. 1841
12
Rebecca Vannest
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.5.2]
b. 24 May 1843 d. 18 Apr 1854
12
Isaac Vannest
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.5.3]
b. 1846
12
Hannah Vannest
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.5.4]
b. 1848
11
Hannah Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.6]
b. 14 Sep 1816 d. 25 May 1837
11
Nathan Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.7]
b. 13 Nov 1818 d. 17 Nov 1863
Candace Ward
b. 1822 d. 1880
12
Rachel Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.7.1]
b. 1843 d. 1890
12
Nancy Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.7.2]
b. 1845 d. 1907
12
David Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.7.3]
b. 9 Mar 1855 d. 1938 [
=>
]
12
Bernard Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.7.4]
b. 5 Oct 1858 d. 12 Nov 1927 [
=>
]
12
Isaac E Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.7.5]
b. Abt 1859
12
William Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.7.6]
b. Abt 1859 d. 1916 [
=>
]
12
Nathan Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.7.7]
b. 1862
11
David Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.8]
b. 22 Dec 1820 d. 16 Oct 1908
Jane King
b. 22 Apr 1824 d. 1911
12
Frances A Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.8.1]
b. 2 Jul 1843 d. 26 Sep 1844
12
John Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.8.2]
b. 24 Jun 1844 d. 26 Sep 1844
12
Elizabeth Sophrone Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.8.3]
b. 14 Oct 1845 d. 17 Sep 1918
12
Charles Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.8.4]
b. 1848 d. Aft 1878
12
DeWitt H Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.8.5]
b. 1853 d. Aft 1887 [
=>
]
12
Harvey D Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.8.6]
b. 28 Jan 1854 d. 8 Jun 1927
12
George Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.8.7]
b. 6 Jun 1857 d. 6 May 1931 [
=>
]
12
Mary Ellen Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.8.8]
b. 19 Jun 1859 d. 8 Jun 1947 [
=>
]
12
Julia Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.8.9]
b. 3 Oct 1863 d. 22 Jul 1864
12
Abbie Olive Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.8.10]
b. 24 Apr 1866 d. 10 Feb 1947 [
=>
]
11
Isaac Campbell Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.9]
b. 22 Feb 1822 d. 5 Dec 1825
11
Levi Tracy Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.10]
b. 19 Oct 1824 d. 4 Sep 1868
Ellen
b. Abt 1831 d. Aft 1850
12
Amanda M Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.10.1]
b. 1850 d. Aft 1850
12
Harriet Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.10.2]
b. 1851
12
Frederick Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.10.3]
b. 1855
12
Evangeline Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.10.4]
b. 1857
12
Judson H Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.10.5]
b. 21 Jul 1861 d. 18 Jul 1947 [
=>
]
12
Ada Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.10.6]
b. Abt 1863
11
Charles Homet Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.3.11]
b. 5 Aug 1826 d. 15 May 1883
10
Sarah Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.4]
b. Abt 1788
+
Daniel Franklin Sims
b. 1789 d. Mar 1866
10
Sybil Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.5]
b. 1790 d. 1810
10
Nathan Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.6]
b. Abt 1792
10
Rachel Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.8.7]
b. Abt 1794
9
Ezra Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.9]
b. 13 Jan 1761
Ruba Ann Herrick
b. 23 Jun 1792 d. 12 Apr 1873
10
Ezra Whipple, Jr
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.1]
b. 26 Oct 1813 d. 22 Aug 1895
Mary Jackson
b. 31 Dec 1814 d. 28 Aug 1883
11
Ezra A Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.1.1]
b. 2 Aug 1838
11
Clark P Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.1.2]
b. 26 Sep 1839 d. 6 Feb 1870
11
Daniel D Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.1.3]
b. 30 Aug 1841 d. Feb 1863
11
Mary S Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.1.4]
b. 7 Dec 1843 d. 26 Jun 1870
+
Orin L Rix
b. Mar 1845
11
Frances M Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.1.5]
b. 6 Sep 1845
11
George A Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.1.6]
b. 1851 d. 1 Feb 1868
11
L Jane Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.1.7]
b. 1853
11
Delia Jane Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.1.8]
b. 25 Feb 1854 d. 8 Jun 1924
Edwin Frank Pierce
b. 20 Aug 1852 d. 27 May 1931
12
Edward Frank "Ezra" Pierce
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.1.8.1]
b. 29 Oct 1874 d. 1945
12
John H Pierce
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.1.8.2]
b. 11 Sep 1876 d. 22 Oct 1932
12
Adelia Edna Pierce
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.1.8.3]
b. 1 Jul 1883 d. Aug 1974
12
Virginia P Pierce
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.1.8.4]
b. 12 Jun 1887 d. 4 Mar 1973
12
Martha Marion Pierce
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.1.8.5]
b. 7 Nov 1888 d. 4 Apr 1935
12
Eva Clark Pierce
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.1.8.6]
b. 19 Jun 1892 d. 1960
12
Frank Coleman Pierce
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.1.8.7]
b. 8 Oct 1893 d. 16 Oct 1944 [
=>
]
12
Babe Pierce
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.1.8.8]
b. 8 Feb 1895
12
Henry Harris Pierce
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.1.8.9]
b. 8 Feb 1895 d. 17 Jan 1958 [
=>
]
11
Eliza A Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.1.9]
b. 30 Oct 1855 d. 29 Apr 1902
Alexander Stewart Lewis
b. 14 Jul 1851 d. 19 Mar 1891
12
Mary Lewis
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.1.9.1]
b. 18 Jan 1874
12
Belle Lewis
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.1.9.2]
b. 17 May 1879
12
Walter A Lewis
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.1.9.3]
b. 18 Jun 1883
11
Laura E Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.1.10]
b. Abt 1856 d. 12 Apr 1869
11
William Franklin Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.1.11]
b. 8 May 1859 d. Aft 21 Apr 1910
Frances Lunette Fletcher
b. Dec 1863
12
Mary E Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.1.11.1]
b. Apr 1880 [
=>
]
10
Robert Bishop Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.2]
b. 16 Oct 1815 d. 1895
Savina Sabra Jackson
b. 1817 d. 1881
11
Mary Ann Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.2.1]
b. 1843
Orrin S Rix
b. Mar 1845 d. 1914
12
Carrie Rix
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.2.1.1]
b. 1868
12
Orrin C Rix
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.2.1.2]
b. 1870 d. 1870
11
John Adams Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.2.2]
b. 10 Nov 1844 d. 15 Nov 1881
Julia Frances Lewis
b. 14 Sep 1845 d. 1925
12
Frank Angel Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.2.2.1]
b. 28 Jul 1867 d. 8 Aug 1936 [
=>
]
12
Charles A Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.2.2.2]
b. Jan 1869 d. 1939 [
=>
]
12
Emma S Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.2.2.3]
b. 1871
12
Mary Ann Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.2.2.4]
b. 13 Nov 1874
12
Lula May Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.2.2.5]
b. 10 Apr 1878 d. 1905
11
Ruby L Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.2.3]
b. 1846
11
Robert Wilbur Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.2.4]
b. Feb 1849 d. 15 Jan 1930
+
Arabella Card
b. 1852
+
Mary E Brachen
b. 1851
11
George H Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.2.5]
b. 13 Dec 1850 d. 1915
Ella J Cleveland
b. Jan 1861 d. 1937
12
Everett Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.2.5.1]
b. 12 Feb 1882 d. 28 Jun 1949
11
Erastus Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.2.6]
b. 1854 d. 1871
10
Ruba Ann "Ruby" Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.3]
b. 16 Oct 1815 d. 8 Nov 1854
Alexander Brown
b. 11 Sep 1810 d. 1 Jun 1850
11
Robert Brown
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.3.1]
b. 1833
11
Charlotte M Brown
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.3.2]
b. 27 Apr 1834 d. 11 Feb 1916
Dwight Dickson
b. 5 Jun 1823 d. 2 Sep 1906
12
William W Dickson
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.3.2.1]
b. Abt 1861
12
Edwin Dwight Dickson
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.3.2.2]
b. 25 Apr 1864
12
Nettie Dixon
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.3.2.3]
b. 1867
11
Eliza Brown
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.3.3]
b. 1836
11
Isaac Brown
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.3.4]
b. 1838
11
Sabria Brown
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.3.5]
b. Abt 1840 d. 1 Apr 1842
11
Erza Brown
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.3.6]
b. 1840
11
John Brown
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.3.7]
b. 1844 d. 29 Jan 1855
Mildred Brown
b. 1841
12
Walton Brown
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.3.7.1]
b. 1861
12
Wiatt Brown
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.3.7.2]
b. 1871
11
Milton Madison Brown
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.3.8]
b. 10 Oct 1845 d. 1 Apr 1918
Margaret Nancy Ann Harter
b. 8 Jan 1846 d. 19 Jan 1891
12
Cora Alena Brown
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.3.8.1]
b. Abt 31 Mar 1865 d. 9 Mar 1955 [
=>
]
12
John Alexander Brown
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.3.8.2]
b. Abt 11 Oct 1865 d. 23 Oct 1941 [
=>
]
12
Joseph Adelbert Brown
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.3.8.3]
b. Abt 5 Dec 1868 d. 7 Jul 1958 [
=>
]
12
Minnie Floralla Brown
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.3.8.4]
b. Abt 24 Dec 1868 d. 5 Feb 1903 [
=>
]
12
Homer Francis Brown
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.3.8.5]
b. 22 Dec 1873 [
=>
]
12
Miner Arthur Brown
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.3.8.6]
b. 15 Sep 1881 d. 9 Jun 1976 [
=>
]
12
Nettie May Brown
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.3.8.7]
b. 24 Jan 1883
+
Mary Morrell
b. Abt 1849
11
Miner A Brown
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.3.9]
b. 10 Oct 1846 d. 1944
Sarah Jane Miner
b. 31 May 1844 d. 8 Mar 1901
12
Fanny M Brown
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.3.9.1]
b. Feb 1873
12
Frank L Brown
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.3.9.2]
b. Oct 1875 d. 1941 [
=>
]
+
Lulu E Northrup
b. 20 Mar 1888 d. 2 Jul 1934
10
Eliza Diana Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.4]
b. 16 Dec 1817 d. 13 Dec 1894
Edward Henry Spicer
b. 15 Mar 1816 d. 8 Aug 1897
11
Abigail D Spicer
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.4.1]
b. 13 May 1839 d. 3 Apr 1880
William W Palmer
b. 1846 d. 1927
12
Edwin S Palmer
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.4.1.1]
b. 1866 d. 29 Nov 1890
12
Henry A Palmer
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.4.1.2]
b. 28 Oct 1869
12
Hattie M Palmer
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.4.1.3]
b. 1870
12
Hallio Palmer
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.4.1.4]
b. 1870
11
Lucy A Spicer
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.4.2]
b. Feb 1844 d. Aft 1930
+
Milo H Denison
b. Jan 1838 d. 24 Jul 1909
11
Henry Alphonso Spicer
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.4.3]
b. 12 Feb 1846 d. 6 Jul 1929
Minnie C Harter
b. 1858 d. 19 May 1927
12
Lulu Bell Spicer
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.4.3.1]
b. Jan 1882 d. 16 Oct 1960
12
Leila B Spicer
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.4.3.2]
b. Feb 1883 d. 11 Dec 1950 [
=>
]
12
Milo Dennison Spicer
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.4.3.3]
b. 5 Apr 1887 d. 28 Nov 1943 [
=>
]
12
Mildred E Spicer
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.4.3.4]
b. 1896 d. 31 Jan 1981 [
=>
]
Alice Jones
b. 1845/1846 d. 1875
12
Carrie J Spicer
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.4.3.5]
b. Apr 1874 d. 1950
11
Mary Irene Spicer
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.4.4]
b. 1848 d. 1920
George P Huntley
b. 1846 d. 1916
12
Benjamin Huntley
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.4.4.1]
b. 1877 d. 1928
11
Everett Livingston Spicer
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.4.5]
b. 1850 d. 31 Mar 1883
Joanna
b. 1858
12
Nellie Spicer
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.4.5.1]
b. 1877
10
John Adams Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.5]
b. 8 Dec 1821 d. 2 Apr 1897
10
Happy Caroline Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.6]
b. 17 Aug 1824 d. 15 Jul 1860
William Tucker
b. 1822 d. 26 Apr 1895
11
Jane E Tucker
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.6.1]
b. 1845 d. 15 Sep 1912
George Irish Maxson
b. 3 Jun 1824 d. 21 Jan 1892
12
Emma J Maxson
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.6.1.1]
b. 1879
12
Lucy E Maxson
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.6.1.2]
b. 1882
11
William H Tucker
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.6.2]
b. 1846 d. 1 Apr 1853
11
James S Tucker
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.6.3]
b. 1847
11
Charles E Tucker
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.6.4]
b. 14 Jun 1849
11
Lemuel W Tucker
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.6.5]
b. 1851 d. Aug 1886
11
John Tucker
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.6.6]
b. 1853
11
Lucy Ann Tucker
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.6.7]
b. 1855
Almon Card
b. 10 Apr 1869 d. 1949
12
William Almon Card
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.6.7.1]
b. 30 Jul 1893
12
Mary Elizabeth Card
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.6.7.2]
b. 20 Oct 1894
11
William H Tucker
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.6.8]
b. 1858
11
Amos T Tucker
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.6.9]
b. 1860 d. 6 May 1860
10
Lucy Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.7]
b. 22 Mar 1826 d. 31 May 1859
James Shay
b. 1825 d. 27 Nov 1860
11
Laury A Shay
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.7.1]
b. 20 Nov 1848 d. 22 Dec 1849
11
John Shay
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.7.2]
b. 26 May 1850 d. 3 Jul 1850
10
Charles H Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.8]
b. 14 Mar 1830 d. 24 Feb 1899
10
Hibbird W Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.9.9]
b. 13 Apr 1833 d. 3 Jun 1866
9
Isaac Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.1.10]
b. 14 Apr 1764
8
Timothy Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2]
b. 28 Oct 1723 d. 4 Nov 1796
Elizabeth Safford
b. 4 Sep 1724 d. 10 Feb 1810
9
Ruth Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.1]
b. 1 Jul 1745 d. 1803
Lieutenant William Brace
b. 1750 d. 1820
10
Hiram Lyman Brace
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.1]
b. 19 Mar 1798 d. 30 Jan 1882
Lydia Bowen
b. 1 Jun 1799 d. 21 Jun 1822
11
William Bowen Brace
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.1.1]
b. 10 Jan 1821 d. 1 Jan 1897
Alvina Resirly Strait
b. 1 Oct 1827 d. 4 Dec 1875
12
Sevellon Alden Brace
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.1.1.1]
b. 14 Jun 1850 d. 15 Feb 1912 [
=>
]
12
William Randolph Brace
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.1.1.2]
b. 20 Oct 1852 d. 8 Jan 1939 [
=>
]
12
Hiram Henry Brace
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.1.1.3]
b. 6 Jun 1855 [
=>
]
12
Harvey Wilkinson Brace
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.1.1.4]
b. 15 Sep 1857 d. Jul 1931 [
=>
]
12
Ann Eliza Brace
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.1.1.5]
b. 10 Feb 1860 d. 2 Sep 1933
12
John Kennard Brace
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.1.1.6]
b. 25 Sep 1862 d. 4 Jul 1879
12
Mary Ida Brace
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.1.1.7]
b. 26 May 1865
12
Charles Wesley Brace
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.1.1.8]
b. 24 Feb 1869 d. 27 Mar 1869
Jane Letson Vroom
b. 1 Apr 1795 d. 25 Mar 1838
11
Jane Letson Brace
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.1.2]
b. 7 Nov 1825 d. 2 Mar 1903
Jared G Kaple
b. 28 Jan 1837 d. 30 Jan 1870
12
Frances Amelia Kaple
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.1.2.1]
b. 19 Sep 1865 [
=>
]
11
George Vroom Brace
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.1.3]
b. Abt 1830 d. 7 Apr 1902
Mary Elizabeth Ketchum
b. 5 May 1830 d. 5 Mar 1865
12
Leander Brace
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.1.3.1]
b. 28 Sep 1858 d. 23 Apr 1907 [
=>
]
12
Emma Etta Brace
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.1.3.2]
[
=>
]
+
Julia Ann Ketchum
b. 19 Apr 1825 d. 17 Apr 1897
11
Hiram Lyman Brace
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.1.4]
b. 6 Jun 1832 d. 17 Feb 1912
Bernetta J Skinner
12
Mary L Brace
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.1.4.1]
b. 28 Mar 1866 [
=>
]
12
Edward Brace
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.1.4.2]
b. 19 Oct 1868
12
James Brace
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.1.4.3]
b. 23 May 1880
11
Sineche Vroom Brace
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.1.5]
b. 8 Aug 1835 d. 24 Oct 1914
Robert Fulton Harris
b. 22 Dec 1827 d. 8 Apr 1912
12
Tirzah Emma Harris
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.1.5.1]
b. 6 Apr 1853 d. 8 Aug 1918 [
=>
]
12
Sylvenus Alden Harris
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.1.5.2]
b. 17 Apr 1856 [
=>
]
12
Bertha Harris
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.1.5.3]
b. Abt 1860
12
James Berthier Harris
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.1.5.4]
b. 10 Jan 1860 d. 28 Jun 1935 [
=>
]
12
Ellsworth D Harris
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.1.5.5]
b. 14 Apr 1862 [
=>
]
12
Mary Elthier Harris
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.1.5.6]
b. 17 Aug 1864 d. 1940 [
=>
]
12
Irene Harris
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.1.5.7]
b. 1866
12
Franklin G Harris
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.1.5.8]
b. 8 Mar 1867 d. 19 Aug 1893
12
Adelia Harris
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.1.5.9]
b. 23 Apr 1869 [
=>
]
12
Bentley Jonathan Harris
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.1.5.10]
b. 2 Nov 1871 d. 15 Apr 1957 [
=>
]
12
Martha J Harris
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.1.5.11]
b. 22 Apr 1878
12
Frelove S Harris
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.1.5.12]
b. 9 May 1878
11
Harvey B Brace
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.1.6]
b. 24 Feb 1838 d. 3 May 1863
Tabitha Pawling
b. 13 Oct 1806
11
Lydia A Brace
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.1.7]
b. 5 Jun 1839
11
Mary P Brace
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.1.8]
b. 17 Jun 1841
11
Francis Elizabeth Brace
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.1.9]
b. 5 Feb 1844
11
Hannah Amina Brace
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.1.10]
b. 18 Jun 1847
11
Sevellon Alden Brace
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.1.11]
b. 28 Feb 1849 d. 1919
Leve S Bundy
b. Dec 1844 d. 1918
12
Walter H Brace
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.1.11.1]
b. 1872 d. 1951
12
Jessie A Brace
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.1.11.2]
b. Sep 1876 d. 1942
Sera
b. Abt 1854
12
Jessie Brace
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.1.11.3]
b. Abt 1877
10
Harvey Brace
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.2]
b. 14 Jul 1801 d. 24 Aug 1875
Elizabeth Van Duyne
b. 17 Jan 1803 d. 31 Oct 1833
11
William Brace
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.2.1]
b. 6 Apr 1822 d. 16 Aug 1823
11
Mary Ann Brace
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.2.2]
b. 10 Oct 1824 d. 16 Apr 1866
Samuel Phelps
12
Charles Phelps
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.2.2.1]
11
Harriet Elizabeth Brace
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.2.3]
b. 30 May 1827 d. 28 Mar 1844
11
Rachael Eliza Brace
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.2.4]
b. 1 Aug 1830 d. 12 Apr 1833
Hannah Thurston Thompson
b. 5 Sep 1811 d. 4 Nov 1854
11
Sarah Minerva Brace
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.2.5]
b. 7 Jan 1837 d. 5 Oct 1894
Smith Norton
b. 1824 d. 12 Apr 1912
12
Morilla Maria Norton
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.2.5.1]
b. 22 Sep 1865 d. 21 Apr 1916
12
Geroge Norton
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.2.5.2]
11
Frances Helen Brace
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.2.6]
b. 11 Sep 1838
+
Joseph Emerson
b. 28 May 1821 d. 4 Aug 1900
11
Marshall Phileman Brace
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.2.7]
b. 21 Dec 1842 d. 1924
Lucy Ellen Clark
b. 20 Aug 1846 d. 1923
12
George Marshall Brace
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.2.7.1]
b. 29 May 1869 d. 24 Aug 1940 [
=>
]
12
Minerva Emily Brace
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.2.7.2]
b. 3 Jan 1871 d. 2 Dec 1875
12
Kathleen Brace
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.2.7.3]
b. 28 Sep 1873 d. 9 Mar 1874
12
Helen Mabel Brace
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.2.7.4]
b. 9 Oct 1874 d. 21 Nov 1875
12
Maria Clark Brace
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.2.7.5]
b. 22 Oct 1879 d. Jan 1950
11
Calista Elizabeth Brace
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.2.8]
b. 7 Feb 1845
+
H D P Bgelow
11
Amanda Hannah Brace
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.2.9]
b. 16 Dec 1849
+
Oscar Crandall
11
Harriet Ella Brace
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.2.10]
b. 4 Feb 1852 d. 1922
Henry Martin Lemon
b. 5 Aug 1850 d. 20 Feb 1918
12
Harvey Brace Lemon
[1.1.4.1.3.2.3.2.1.2.10.1]
b. 23 Apr 1885 d. 1965 [
=>
]
9
Mercy Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.2]
b. 15 Mar 1747 d. 23 Dec 1843
William Riley McCraney
b. 21 Aug 1750 d. 1823
10
Ruth Cranney
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.1]
b. 1771
10
Hannah Cranney
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.2]
b. 1773
10
William Cranney
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.3]
b. 10 Nov 1775 d. 30 Jan 1854
Nancy Ann Cranmer
b. 27 Mar 1784 d. 22 May 1851
11
Emiline Wire Cranney
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.3.1]
b. 1 Jun 1815 d. 11 Aug 1887
+
Joel Hills Johnson
b. 1815
James Nathan Drake
b. 10 May 1822 d. 19 Sep 1889
12
Harriett A Drake
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.3.1.1]
b. 15 Dec 1851 d. 20 Dec 1931 [
=>
]
12
William Ora Drake
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.3.1.2]
b. 11 Feb 1855 d. 21 Mar 1928 [
=>
]
11
Philander Cranney
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.3.2]
b. 24 Dec 1816 d. 27 Nov 1898
Louisa Ellen Bryan
b. 1824 d. 1867
12
Hellen Cranney
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.3.2.1]
b. 8 Oct 1844 d. Abt 1918 [
=>
]
12
Alfred William Cranney
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.3.2.2]
b. 29 Aug 1846 d. 15 Nov 1920
12
Adalade Cranney
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.3.2.3]
b. Abt 1855
Nancy Jane Sharp
b. 15 Jun 1848 d. 11 Mar 1900
12
Emma Jane Cranney
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.3.2.4]
b. 29 Apr 1866 d. 21 Apr 1878
12
Mary Alverta Cranney
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.3.2.5]
b. 26 Nov 1868 d. 29 Apr 1870
+
Roxanna Catherine Crockett
b. 26 Sep 1834 d. 23 Nov 1900
+
Eliza Ann Perry
b. 30 Mar 1828 d. 30 Apr 1913
11
Hyrum Kingsley Cranney
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.3.3]
b. 26 Feb 1818 d. 20 Feb 1896
Elizabeth Boughey
b. 15 Mar 1825 d. 5 Jun 1911
12
Olivia Jeannette Cranney
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.3.3.1]
b. 13 Jan 1847 d. Mar 1856
12
Willard Duane Cranney
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.3.3.2]
b. 24 Aug 1848 d. 10 Mar 1941 [
=>
]
12
Harriet Irene Cranney
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.3.3.3]
b. 21 Jul 1850 d. 14 Sep 1905 [
=>
]
Elizabeth Crook
b. 7 Oct 1828 d. 15 Mar 1891
12
Hyrum Kingsley Cranney, Jr
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.3.3.4]
b. 10 Jun 1865 d. 8 Aug 1903
12
Frank Philander Cranney
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.3.3.5]
b. 11 Jan 1867 d. 19 Feb 1946 [
=>
]
12
Lorton Morton Cranney
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.3.3.6]
b. 12 Nov 1868 d. 26 Mar 1940 [
=>
]
12
Adelbert Ezra Cranney
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.3.3.7]
b. 30 Apr 1870 d. 27 Feb 1944 [
=>
]
12
Wilford Woodruff Cranney
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.3.3.8]
b. 24 May 1872 d. 18 Oct 1951 [
=>
]
12
Emmaline Cranney
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.3.3.9]
b. 1 Jun 1874 d. 1 Mar 1953 [
=>
]
12
Clara May Cranney
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.3.3.10]
b. 3 Mar 1877 d. 3 Oct 1877
Elizabeth White
b. 19 Nov 1849 d. 2 Nov 1914
12
Laura Cranney
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.3.3.11]
b. 18 Dec 1868 d. 29 Dec 1868
12
Clyde Parley Cranney
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.3.3.12]
b. 28 Dec 1869 d. 10 Aug 1886
12
Wilber Thomas Cranney
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.3.3.13]
b. 4 Jan 1872 d. 21 Aug 1950 [
=>
]
12
Loretta Cranney
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.3.3.14]
b. 16 Feb 1874 d. 2 Feb 1963 [
=>
]
12
Lillus Cranney
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.3.3.15]
b. 3 Jul 1876 d. 25 Sep 1877
12
Ora Cranney
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.3.3.16]
b. 25 Jul 1879 d. 25 Feb 1883
12
Ara Cranney
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.3.3.17]
b. 29 Jul 1880 d. 1 Mar 1883
12
Kate Mable Cranney
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.3.3.18]
b. 8 Mar 1882 d. 29 Jul 1963 [
=>
]
12
Sarah Ellen Cranney
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.3.3.19]
b. 27 Dec 1884 d. 17 Mar 1887
12
Ivy Myrtle Cranney
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.3.3.20]
b. 14 Mar 1888 d. 3 May 1948 [
=>
]
12
Hazel Cranney
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.3.3.21]
b. 20 Mar 1894 d. 27 Oct 1916
11
Darius Cranney
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.3.4]
b. 15 Feb 1821 d. 1880
10
John Cranney
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.4]
b. 1777
Achsah Hurlbert
b. 16 Dec 1797 d. 1822
11
Clarissa Cranney
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.4.1]
b. Abt 1821 d. 27 Jun 1904
Thomas Hunter
b. 1810
12
Howard Hunter
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.4.1.1]
b. 1842
12
William Hunter
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.4.1.2]
b. 1844
12
Mary E Hunter
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.4.1.3]
b. 1848
10
Desire Cranney
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.5]
b. 1779
Thaddeus Perry, Jr
b. 18 Jul 1783 d. Abt 1840
11
Ann Perry
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.5.1]
b. Abt 1801 d. 1880
John Shevalier
b. 15 Oct 1799 d. 6 Jun 1866
12
Elizabeth Shavalier
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.5.1.1]
b. 17 May 1822 d. 31 Dec 1906 [
=>
]
12
Jeremiah Shavalier
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.5.1.2]
b. Abt 1823 d. 2 Oct 1824
12
Dix A Shavalier
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.5.1.3]
b. 18 Jul 1824 d. 29 Jun 1854
12
John Shevalier
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.5.1.4]
b. 8 Feb 1827 d. 2 Oct 1893 [
=>
]
12
Abigail L Shevalier
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.5.1.5]
b. 26 Nov 1828 d. 1866 [
=>
]
12
Isaac Shavalier
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.5.1.6]
b. 19 Aug 1830 d. 16 Mar 1878 [
=>
]
12
Charles Shavalier
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.5.1.7]
b. Abt 1831 d. 12 Feb 1886
12
James B Shevalier
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.5.1.8]
b. 20 Jul 1834 d. 30 Dec 1903 [
=>
]
12
Christian Shevalier
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.5.1.9]
b. Abt 1836 d. 20 Oct 1867 [
=>
]
12
Albert Shavalier
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.5.1.10]
b. Abt 1838 d. 15 Jun 1845
12
Almeren Shavalier
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.5.1.11]
b. Abt 1840 d. 25 Sep 1841
12
Depuy Shevalier
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.5.1.12]
b. 10 Oct 1844 d. 5 Dec 1894 [
=>
]
11
Joseph Perry
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.5.2]
b. 1807
+
Kizzaria Carter
b. Abt 1811
11
Leander Perry
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.5.3]
b. 9 Mar 1809 d. 23 May 1887
Sarah Ann Jones
b. 30 Jun 1813 d. 27 Jul 1889
12
Adaline Perry
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.5.3.1]
b. 10 Mar 1834 d. 8 Dec 1856 [
=>
]
12
Susan Perry
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.5.3.2]
b. 7 Apr 1836 d. 17 Nov 1883 [
=>
]
12
Elizabeth Agnes Perry
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.5.3.3]
b. 12 May 1838 d. 11 May 1924 [
=>
]
12
Albert Gallatin Perry
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.5.3.4]
b. 1 Dec 1840 d. 14 Jun 1909 [
=>
]
12
Oliver Hazard Perry
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.5.3.5]
b. 24 Nov 1842 d. 6 Dec 1925
12
Mary A Perry
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.5.3.6]
b. 18 Dec 1844 d. 18 Oct 1934 [
=>
]
12
Alexander J Perry
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.5.3.7]
b. 6 Mar 1847 d. 20 Dec 1907 [
=>
]
12
Charles Willard Perry
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.5.3.8]
b. 21 Aug 1849 d. 4 Nov 1900 [
=>
]
12
Nancy L Perry
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.5.3.9]
b. 28 Sep 1851 d. 2 Sep 1933 [
=>
]
11
Nancy Perry
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.5.4]
b. Abt 1815
11
Thaddeus Perry
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.5.5]
b. 1818
Mary Estes
b. 1 Nov 1823
12
Louisa Perry
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.5.5.1]
b. 1845
12
Franklin Perry
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.5.5.2]
b. 1850
12
Melissa Perry
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.5.5.3]
b. Abt 1855 d. Bef 1940 [
=>
]
11
Mercy Perry
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.5.6]
b. 1821
11
Clarissa Perry
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.5.7]
b. Abt 1822 d. 11 Nov 1905
Daniel Minkler
b. 25 Oct 1812 d. 8 Apr 1853
12
Mary Lucinda Minkler
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.5.7.1]
b. 1837 d. 1878 [
=>
]
12
Barnabas Minkler
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.5.7.2]
b. 22 Mar 1845 d. 15 Dec 1908
12
Sarah Jane Minkler
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.5.7.3]
b. 25 Sep 1847 d. 30 Mar 1930 [
=>
]
12
Julia Ann Minkler
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.5.7.4]
b. 14 Feb 1852 d. 26 Oct 1933
12
Clarissa Minkler
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.5.7.5]
b. 17 May 1852 d. 25 Jun 1919 [
=>
]
Martin Clinton Lesley
b. 25 Oct 1831 d. 24 Mar 1906
12
Jasper Newton Lesley
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.5.7.6]
b. 15 Jun 1856 d. 27 Dec 1928 [
=>
]
12
Amelia Ida Lesley
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.5.7.7]
b. 8 Feb 1859 d. 22 Nov 1882 [
=>
]
10
Mercy Cranney
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.6]
b. 1781 d. 10 Feb 1805
10
Gad Cranney
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.7]
b. 1784
Sady Blanchard
b. 2 Sep 1786
11
Fanny Cranny
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.7.1]
b. 14 Oct 1807
Parley Dewey Shumway
b. 12 Oct 1808 d. 25 Mar 1840
12
Lucy Malinda Shumway
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.7.1.1]
b. 30 Oct 1837
Jared Allyn Stillman
b. 24 Jan 1790
12
Allen Stillman
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.7.1.2]
b. 28 Nov 1843 d. 27 Jun 1931
11
Robert Craney
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.7.2]
b. 1811
+
Hannah Telling
c. 21 May 1815
11
Nancy Cranney
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.7.3]
b. 9 Jun 1814 d. 9 Apr 1886
John Alanson Hale
b. 1 Jun 1818 d. 11 Sep 1855
12
Sarah Eliza Hale
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.7.3.1]
b. 14 Aug 1835 d. 13 Jun 1932 [
=>
]
12
William A Hale
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.7.3.2]
b. 14 Oct 1843 d. 13 Jun 1908 [
=>
]
12
Ella Hale
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.7.3.3]
b. 1850 d. 1934 [
=>
]
11
Alfred Cranney
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.7.4]
b. 12 Oct 1816 d. Abt 1853
+
Susan Sawtell
b. Abt 1818
10
Clarissa Cranney
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.8]
b. 3 Aug 1788 d. 26 Jun 1814
Moses Deming
b. 4 Dec 1777 d. 9 Dec 1868
11
Clarissa Cranney Deming
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.8.1]
b. 16 Jun 1814 d. 22 Apr 1904
George Lewis
b. 1810 d. 20 Aug 1861
12
Son Lewis
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.8.1.1]
b. 12 Mar 1836
12
George Henry Lewis
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.8.1.2]
b. 23 Jun 1838 d. 2 Jun 1894
12
Delia A Lewis
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.8.1.3]
b. 28 Sep 1839
12
Charles B Lewis
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.8.1.4]
b. 15 Feb 1842
12
Francis M Lewis
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.8.1.5]
b. 16 May 1844 d. 30 Jan 1918 [
=>
]
12
William L Lewis
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.8.1.6]
b. 12 Dec 1845 d. 4 Oct 1867
12
Isabelle Lewis
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.8.1.7]
b. 21 May 1847 d. 9 May 1928 [
=>
]
12
James Lewis
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.8.1.8]
b. 3 Aug 1850
12
Arthur Lewis
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.8.1.9]
b. 10 May 1854
12
Helen M Lewis
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.8.1.10]
b. 30 Dec 1856 [
=>
]
12
Archie Lewis
[1.1.4.1.3.2.3.2.2.8.1.11]
b. 6 May 1858
9
Dorothy Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.3]
b. 19 Apr 1750 d. 17 May 1830
Noah Bennett
b. 4 Jul 1746 d. 25 Nov 1833
10
Derastus Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.1]
b. 6 Sep 1770 d. 10 Mar 1859
+
Electa Ward
b. 17 Jan 1795 d. 5 Apr 1886
10
Safford Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.2]
b. 29 Jul 1772 d. 1774
10
Safford Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.3]
b. 28 May 1774 d. 7 Apr 1860
Sarah Blakeslee
b. 1 May 1775 d. 23 Apr 1858
11
Susan Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.3.1]
b. 1 Jul 1799 d. 11 Jul 1799
11
Edwin Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.3.2]
b. 20 Jun 1800 d. 18 Sep 1891
Julia A Carr
b. 1821 d. 3 May 1892
12
Samantha Amanda Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.3.2.1]
b. Oct 1852 d. 12 Nov 1927 [
=>
]
11
Edson Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.3.3]
b. 1802
Priscilla R Farwell
b. 18 Jan 1802
12
Oliver Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.3.3.1]
b. 1834
12
Henry Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.3.3.2]
b. 1836
12
William F Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.3.3.3]
b. Abt 1839 [
=>
]
12
William Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.3.3.4]
b. 1841
12
Leverett L Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.3.3.5]
b. 1842 d. 25 Mar 1850
11
Nancy Adeline Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.3.4]
b. 18 Feb 1805 d. 18 Oct 1897
+
William Stedman
11
Mary Ann Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.3.5]
b. 4 Aug 1811 d. 11 Sep 1903
11
Rebecca Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.3.6]
b. 27 Oct 1815 d. 12 Nov 1857
11
Emily Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.3.7]
b. 17 Sep 1817 d. 7 Mar 1912
Erastus Mills
b. 25 Jan 1814 d. 12 Jul 1904
12
Albert Erastus Mills
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.3.7.1]
b. 7 Aug 1843 d. 27 Oct 1917 [
=>
]
12
Alfred Burton Mills
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.3.7.2]
b. 25 May 1852 d. 21 May 1853
12
Ernest Edward Mills
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.3.7.3]
b. 24/26 Jul 1854 d. Feb 1936 [
=>
]
12
Sarah Emily Mills
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.3.7.4]
b. 22 Nov 1856 d. 24 Jul 1904
12
Emma Jane Mills
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.3.7.5]
b. 8 Sep 1863 d. 25 Nov 1933 [
=>
]
11
Edmund Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.3.8]
b. 17 Sep 1817 d. 26 Feb 1879
Charlotte Ann Goddard
b. 6 Apr 1824 d. 5 Dec 1911
12
Charlotte Almira Bennet
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.3.8.1]
b. 17 May 1847 d. 10 Mar 1887
12
Lydia Ann Bennet
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.3.8.2]
b. 6 Feb 1849 d. 16 Mar 1924
12
Sarah Lucinda Bennet
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.3.8.3]
b. 26 Apr 1851 d. 17 Feb 1874
12
David Edmund Bennet
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.3.8.4]
b. 29 Mar 1853
12
Margaret Emily Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.3.8.5]
b. 13 Jul 1853 d. 19 Apr 1855
12
Calvin Goddard Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.3.8.6]
b. 8 Nov 1855 d. 16 Jan 1926 [
=>
]
12
David Edmund Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.3.8.7]
b. 20 Mar 1858 d. 15 Feb 1950 [
=>
]
12
Margaret Emily Bennet
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.3.8.8]
b. 1 Jul 1861 d. 27 Apr 1862
12
Flora Carlotta Bennet
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.3.8.9]
b. 1 Apr 1863 [
=>
]
12
Effie May Bennet
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.3.8.10]
b. 7 Apr 1865 d. 16 Aug 1866
10
Elizabeth Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.4]
b. 26 May 1776
10
Nancy Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.5]
b. Feb 1779
10
Dolly Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.6]
b. 29 Aug 1781 d. 18 Nov 1853
10
Noah Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.7]
b. 6 Jul 1784 d. 3 Oct 1842
10
Cynthia Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.8]
b. 8 May 1786 d. 30 Apr 1873
Elias Samson
b. 1787 d. 15 Nov 1821
11
Phebe Wheeler Samson
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.8.1]
b. 25 Sep 1811 d. 1881
+
Nathaniel Goodspeed
b. 20 May 1789 d. 30 May 1883
11
Delia Maria Sampson
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.8.2]
b. 13 Aug 1813 d. 13 Feb 1861
Alvarus Lawrence
b. 23 Dec 1813 d. 9 Oct 1891
12
Francis Lawrence
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.8.2.1]
b. 1836 d. 26 Mar 1858
12
Maria Ellen Lawrence
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.8.2.2]
b. 1838
12
Henry E Lawrence
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.8.2.3]
b. 1839
12
Mary Louisa Lawrence
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.8.2.4]
b. 1842 [
=>
]
12
Roswell N Lawrence
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.8.2.5]
b. 1845
12
Sarah Jennie Lawrence
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.8.2.6]
b. 1847 d. 18 Nov 1872
11
Noah Bennett Samson
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.8.3]
b. 16 Nov 1816 d. 6 Jan 1897
Caroline Allen
b. 1820 d. 25 Feb 1882
12
Sarah A Samson
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.8.3.1]
b. 6 Dec 1842 d. 30 Apr 1915 [
=>
]
12
Cynthia Aurilla Samson
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.8.3.2]
b. 18 Aug 1844 d. 24 Oct 1928 [
=>
]
12
Frederick E Samson
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.8.3.3]
b. 10 Jun 1848 d. 30 Jan 1924 [
=>
]
12
William Allen Samson
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.8.3.4]
b. 6 Dec 1850 d. 18 Oct 1935 [
=>
]
12
Carrie J Sampson
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.8.3.5]
b. 1854 d. 19 Oct 1888
10
Almena Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.9]
b. 19 Jun 1788 d. 6 Feb 1875
Nathan F Park
b. 1 Jun 1794 d. 18 Mar 1860
11
Derastus Bennett Park
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.9.1]
b. 2 Nov 1819 d. Aug 1894
Sarah Howe Barker
b. Apr 1827 d. Nov 1898
12
Fredrick Y Park
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.9.1.1]
b. 1851 d. 1898
12
Addison Barker Park
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.9.1.2]
b. 12 Oct 1853 d. 7 Jun 1940
12
Herbert R Park
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.9.1.3]
b. 1856
12
Jessie Louisa Park
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.9.1.4]
b. 1861 d. 13 Aug 1929 [
=>
]
12
Roland Francis Park
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.9.1.5]
b. 29 Mar 1865 d. 21 Jan 1931 [
=>
]
11
Adeline Park
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.9.2]
b. 13 Jun 1821 d. 11 Mar 1831
11
Pliny Fisk Park
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.9.3]
b. 6 Apr 1823 d. 9 Dec 1917
Elizabeth F Park
b. Jun 1846
12
Cornela A Stillman
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.9.3.1]
b. 1850
11
Almena Louisa Park
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.9.4]
b. 12 Apr 1827
11
Sarah Park
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.9.5]
b. 20 Dec 1828
11
Lucy C Park
[1.1.4.1.3.2.3.2.3.9.6]
b. 1835
9
Elizabeth Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.4]
b. 1 Jan 1753 d. 31 Dec 1829
Jonathan Welles
b. 7 Mar 1753 d. 5 Jan 1778
10
Emeline Wells
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.1]
b. 1775 d. 13 Mar 1813
Edmund F Bennett
b. 1771 d. 1812
11
Harriett T Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.1.1]
b. Abt 1798
11
Albert Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.1.2]
b. Abt 1798 d. 27 Oct 1875
Mary Salisbury
b. 8 Nov 1816 d. 26 Apr 1864
12
Edmund Ferdinand Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.1.2.1]
b. 8 Dec 1825 d. 4 May 1846
12
Emmaline Wells Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.1.2.2]
b. 28 Dec 1828 d. 22 Jan 1896 [
=>
]
12
Mary Elizabeth Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.1.2.3]
b. 4 Mar 1830 d. 22 Mar 1856 [
=>
]
12
James Wilfred Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.1.2.4]
b. 17 Jun 1831 d. 30 Sep 1867 [
=>
]
12
Simeon Salisbury Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.1.2.5]
b. 16 Sep 1832 d. 18 Jan 1895 [
=>
]
12
John Newton Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.1.2.6]
b. 28 Mar 1836 d. 24 Jul 1863
12
Albert Alphonse Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.1.2.7]
b. 8 Nov 1837 d. 8 Oct 1863
11
Elizabeth W Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.1.3]
b. Abt 1800
11
Catherine N Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.1.4]
b. 1802
11
Lucinda Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.1.5]
b. 1804
11
Edmund Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.1.6]
b. Abt 1808
11
George Hamilton Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.1.7]
b. 9 Jul 1810 d. 25 Jun 1894
Harriet Amanda Houghton
b. 20 Jun 1819 d. 10 Apr 1896
12
Henry Hamilton Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.1.7.1]
b. 15 Jan 1843 d. 1 Jan 1908 [
=>
]
12
Edmund Franklin Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.1.7.2]
b. 25 Oct 1844 d. 27 Dec 1906 [
=>
]
12
George Chapin Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.1.7.3]
b. 1 Feb 1846 d. 14 Mar 1915 [
=>
]
12
Sarah Mariah Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.1.7.4]
b. 29 Dec 1847 d. 17 Mar 1920 [
=>
]
12
Albert Irving Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.1.7.5]
b. 8 Aug 1850 d. 3 Jan 1912 [
=>
]
12
Charles Souther Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.1.7.6]
b. 24 Mar 1853 d. 17 Apr 1926 [
=>
]
12
Willie Seymour Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.1.7.7]
b. 8 Apr 1855 d. 28 Aug 1855
12
Clarence Carpenter Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.1.7.8]
b. 26 Jul 1856 d. 11 Oct 1935 [
=>
]
12
John Wheeler Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.1.7.9]
b. 3 Nov 1857
12
Don Alonzo Edgar Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.1.7.10]
b. 12 Jul 1859 d. 18 May 1928 [
=>
]
12
Arthur Morse Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.1.7.11]
b. 17 Jun 1862 d. 7 Oct 1941 [
=>
]
12
Harriett Elizabeth Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.1.7.12]
b. 2 Jul 1865 d. 27 Jun 1916
Lieutenant Reuben Church
b. 21 Mar 1757 d. 18 Sep 1839
10
Reuben Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.2]
b. 6 Dec 1782 d. 23 Sep 1821
Mary "Polly" Walton
b. 12 Nov 1789 d. 29 Aug 1832
11
Peres Walton Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.2.1]
b. 2 Sep 1809 d. 12 Feb 1853
Elizabeth Reece
b. Abt 1818
12
William Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.2.1.1]
b. Abt 1840
12
Mariah Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.2.1.2]
b. 1845
12
James Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.2.1.3]
b. 1847
12
David Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.2.1.4]
b. 1847
12
Rebecca Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.2.1.5]
b. 1850
11
David Glazier Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.2.2]
b. 6 Jul 1811 d. 14 Nov 1878
Mary Jane Saxton
b. 27 Mar 1815 d. 3 May 1875
12
James Rupert Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.2.2.1]
b. 16 Jun 1836 d. 24 Jan 1913 [
=>
]
12
Reuben Francis Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.2.2.2]
b. 17 Feb 1840 d. 17 Apr 1920 [
=>
]
12
Samuel K Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.2.2.3]
b. 18 Jun 1842 d. 16 Oct 1910
12
Henry Sharp Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.2.2.4]
b. 26 Mar 1845 [
=>
]
12
Mary Jane Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.2.2.5]
b. 25 Oct 1847 [
=>
]
12
Lucinda Ann Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.2.2.6]
b. May 1850 [
=>
]
12
Eliza M "Lida" Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.2.2.7]
b. 9 Apr 1853 d. 23 Feb 1923 [
=>
]
11
Elvira A Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.2.3]
b. 5 Nov 1812
11
Reuben Whipple Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.2.4]
b. 4 Sep 1815 d. 4 Feb 1894
Mary Reece
b. 24 Nov 1818 d. 29 Aug 1852
12
Rebecca Jane Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.2.4.1]
b. 17 Apr 1837 d. 3 Oct 1844
12
Hannah Alvira Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.2.4.2]
b. 17 Jun 1839 d. 23 Aug 1856
12
David Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.2.4.3]
b. 8 Apr 1841 d. 4 Jan 1876 [
=>
]
12
William Walton Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.2.4.4]
b. 3 Sep 1843 d. 15 Feb 1899
12
Mary Elizabeth Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.2.4.5]
b. 28 May 1846
12
James Henry Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.2.4.6]
b. 1 Nov 1848
12
Nancy Ann Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.2.4.7]
b. 9 Jan 1851 d. Mar 1928 [
=>
]
Mary Ann Crossfield
b. 2 Nov 1831 d. 4 Oct 1889
12
Elias Theodore Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.2.4.8]
b. 6 Nov 1857 d. 4 Mar 1906
12
John Charles Freemont Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.2.4.9]
b. 23 May 1859 d. 2 Feb 1922 [
=>
]
11
John B Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.2.5]
b. 26 Feb 1818
11
James P Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.2.6]
b. 22 Jul 1820
Mary M Shaw
12
William G Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.2.6.1]
b. 1852 [
=>
]
12
Jasper Marion Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.2.6.2]
b. 1854 bur. 18 May 1934 [
=>
]
12
Mary Alice Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.2.6.3]
b. 1856 d. 2 Apr 1918 [
=>
]
12
Harrison A Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.2.6.4]
b. 1860
12
Sarah Etta Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.2.6.5]
b. 1865 d. 15 May 1932 [
=>
]
11
Elias Newton Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.2.7]
b. 31 Aug 1821 d. 19 Feb 1908
Elizabeth Cooper
b. Abt 1834 d. 31 Aug 1863
12
William Reuben Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.2.7.1]
b. Mar 1850 d. 27 Mar 1917
12
David A Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.2.7.2]
b. Abt 1852 d. 1864
12
Hannah M Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.2.7.3]
b. 17 Mar 1854 d. Jun 1897 [
=>
]
12
Mary E Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.2.7.4]
b. 1857
12
Elias Newton Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.2.7.5]
b. 9 Jun 1859 d. 10 Dec 1912 [
=>
]
12
Sarah Eliza Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.2.7.6]
b. 19 Aug 1861 d. 16 Aug 1898 [
=>
]
12
George J Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.2.7.7]
b. Apr 1863 d. 15 Jul 1865
Mary Ann Connor
b. Apr 1842 d. 1939
12
Anna May Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.2.7.8]
b. 1866 d. 18 Nov 1920
12
Addie Bell Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.2.7.9]
b. 1868
12
Charles E Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.2.7.10]
b. 1870 d. 1870
12
Andrew Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.2.7.11]
b. 1872
10
Elizabeth Letitia Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.3]
b. 22 Mar 1784 d. 21 Feb 1835
Simon Griggs
b. 23 Oct 1779 d. 29 Apr 1843
11
Jared Church Griggs
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.3.1]
b. 3 Feb 1804 d. 17 Feb 1875
Nancy Griggs
b. 5 May 1799
12
Truman Church Griggs
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.3.1.1]
b. 9 May 1838 d. 28 Jan 1917 [
=>
]
11
Sarah "Sally" Griggs
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.3.2]
b. 10 Aug 1806 d. 1 Feb 1841
+
John Dixon
b. Abt 1805
11
Margaret Griggs
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.3.3]
b. Abt 1809
Cyrus Alexander
b. Abt 1810
12
Abraham Alexander
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.3.3.1]
b. Abt 1828
12
Henry Alexander
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.3.3.2]
b. Apr 1832 d. 15 Aug 1900 [
=>
]
12
Mary Jane Alexander
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.3.3.3]
b. Abt 1835 d. 17 Sep 1923 [
=>
]
12
Eugene S Alexander
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.3.3.4]
b. 25 Dec 1840 d. 13 Jan 1923 [
=>
]
12
Arthur Alexander
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.3.3.5]
b. Sep 1842
12
Carlos H Alexander
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.3.3.6]
b. 15 Jan 1846 d. 21 Sep 1929 [
=>
]
12
Alice M Alexander
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.3.3.7]
b. Abt 1849
11
Hannah Griggs
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.3.4]
b. Abt 1812
Andrew Horner
b. Abt 1810
12
Oscar Alonzo Horner
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.3.4.1]
b. 24 Jan 1838 d. 20 Mar 1842
11
Emaline Griggs
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.3.5]
b. 28 Dec 1815
Marcus Child Hall
b. 1819 d. Abt 1860
12
Henry Carlton Hall
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.3.5.1]
b. 24 Aug 1841 d. 14 Aug 1911 [
=>
]
12
Harriet Amelia "Hallie" Hall
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.3.5.2]
b. 23 Feb 1845 d. Abt 1944 [
=>
]
12
Proctor Wellington Hall
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.3.5.3]
b. 24 Apr 1847 d. 24 Jun 1906
11
Reuben Church Griggs
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.3.6]
b. 5 Mar 1819 d. 7 Apr 1885
Aurora Nancy Williamson
b. 17 Mar 1831 d. Jun 1886
12
Anna Louisa Griggs
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.3.6.1]
b. 15 Apr 1854 d. Bef 1871
12
Alvin Augustus Griggs
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.3.6.2]
b. 4 Oct 1855 d. 22 Jan 1935 [
=>
]
12
Emily Cecilia Griggs
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.3.6.3]
b. 31 Jul 1856 d. 7 Mar 1901 [
=>
]
12
Marcus Childs Hall Griggs
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.3.6.4]
b. 23 Dec 1859 d. 6 May 1885
12
Albert Ernest Griggs
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.3.6.5]
b. 22 May 1861 d. 14 Jun 1922 [
=>
]
12
Ida Aurora Griggs
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.3.6.6]
b. 31 Aug 1863 d. 22 Jul 1882
12
Flora Elizabeth Griggs
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.3.6.7]
b. 15 Mar 1865 d. Abt 1874
12
Melvin Alonzo Griggs
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.3.6.8]
b. 3 Feb 1867 d. 1867
12
Nettie Almira Griggs
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.3.6.9]
b. 14 Aug 1870
12
Hattie Ann Griggs
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.3.6.10]
b. 11 Apr 1873 [
=>
]
11
George D Griggs
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.3.7]
b. Jun 1821 d. 11 May 1822
11
Alvin Griggs
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.3.8]
b. 17 May 1825
10
Jonathan Wells Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.4]
b. 2 Apr 1786 d. 10 Jun 1833
Mercy Carter
b. 1785 d. 1825
11
Abigail Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.4.1]
b. 6 Jul 1803
11
Eugene Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.4.2]
b. 8 Apr 1811 d. 3 Aug 1836
11
Benjamine Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.4.3]
b. 20 Feb 1813 d. Nov 1869
11
Jane A Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.4.4]
b. 27 Sep 1816 d. 21 Oct 1893
11
Elvira Roxana Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.4.5]
b. 24 Oct 1818 d. 24 Nov 1909
Almon Eddy
b. 28 Jan 1815 d. 19 Jan 1884
12
Helen Jane Eddy
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.4.5.1]
b. 1 Apr 1843 d. 11 Jul 1932 [
=>
]
12
Alice Emma Eddy
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.4.5.2]
b. 8 Feb 1846 d. 16 May 1887 [
=>
]
12
Grace Green Eddy
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.4.5.3]
b. 13 Mar 1850 d. 18 Mar 1928
12
Lizzie Elvira Eddy
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.4.5.4]
b. 28 Dec 1856 d. 16 Apr 1887 [
=>
]
12
Daughter Eddy
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.4.5.5]
b. 28 Dec 1858
11
Elizabeth Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.4.6]
b. 10 Apr 1821 d. 17 May 1825
11
Mercy Carter Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.4.7]
b. 18 Feb 1825 d. 23 Feb 1904
10
Mary Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.5]
b. 6 Feb 1791 d. 25 Jan 1823
10
Alonzo Christy Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.6]
b. 9 Apr 1793 d. 18 May 1862
Sarah Jane Trippe
b. 1 Nov 1801 d. 19 Apr 1861
11
Elvira Ann Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.6.1]
b. 8 Oct 1818 d. 12 Nov 1881
William Hollinshead Lee
b. 3 Mar 1818 d. 25 Apr 1852
12
William Hollinshed Lee
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.6.1.1]
b. 6 Dec 1841 d. 27 Dec 1910 [
=>
]
12
Alonzo Church Lee
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.6.1.2]
b. Apr 1843 d. 1910 [
=>
]
11
Sarah Jane Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.6.2]
b. 21 Oct 1820 d. 12 Dec 1890
Benjamin Franklin Whitner
b. 23 Sep 1819 d. 29 Apr 1881
12
Alonzo Church Whitner
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.6.2.1]
b. 29 Apr 1841 d. 23 Sep 1888 [
=>
]
12
Captain Benjamin Franklin Whitner
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.6.2.2]
b. 7 Aug 1842 d. 15 Nov 1913 [
=>
]
11
Elizabeth Whipple Hunt Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.6.3]
b. 22 Sep 1823 d. 6 Jan 1868
Lewis Stevenson Craig
b. 1805 d. 6 Jun 1852
12
Sarah Church Craig
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.6.3.1]
b. 18 Sep 1844 d. 28 Dec 1881 [
=>
]
11
Julia Maria Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.6.4]
b. 8 May 1824
George Alexander Croom
b. 1820 d. 30 Apr 1888
12
Hardy Bryan Church Croom
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.6.4.1]
b. 1844 d. 1904 [
=>
]
12
Alonzo Church Croom
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.6.4.2]
b. 1 Dec 1845 [
=>
]
12
William Church Croom
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.6.4.3]
b. 18 Feb 1847 d. 6 Jul 1854
12
Sarah Jane Church Croom
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.6.4.4]
b. 29 Jul 1848 d. 7 Aug 1912 [
=>
]
12
Julia Church Croom
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.6.4.5]
b. 5 Oct 1850 d. 26 Nov 1915 [
=>
]
12
Elizabeth Church Croom
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.6.4.6]
b. 4 Feb 1852 d. 10 Jul 1854
12
William Harrison Croom
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.6.4.7]
b. Abt 1854
12
Anne Eloise Croom
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.6.4.8]
b. 10 Dec 1854 d. 16 May 1919
12
Louisa Whitfield Croom
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.6.4.9]
b. 1 Apr 1859
11
Cornelia W Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.6.5]
b. 8 May 1826 d. 13 May 1830
11
Mary A J Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.6.6]
b. 9 Feb 1828 d. 19 Mar 1828
11
Alonzo Webster Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.6.7]
b. 16 Feb 1829 d. 12 Aug 1909
Mary Ann Robbins
b. 23 Jun 1835 d. 17 Oct 1897
12
Samuel Robbins Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.6.7.1]
b. 24 Dec 1863 d. 4 Jan 1945 [
=>
]
12
John Robbins Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.6.7.2]
b. 13 Nov 1865 d. 8 Dec 1865
12
James Robbins Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.6.7.3]
b. 11 Oct 1866 d. 28 Oct 1923 [
=>
]
12
Sarah Robbins Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.6.7.4]
b. 24 Jan 1868 d. 22 Oct 1869
12
Mary Robbins "Minnie" Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.6.7.5]
b. 29 Jun 1869 d. 20 Jul 1939
12
Alonzo Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.6.7.6]
b. 31 Oct 1870 d. 20 Feb 1937
12
William Wells Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.6.7.7]
b. 13 Dec 1874 d. 1947
11
John Reuben Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.6.8]
b. 1831 d. 1862
11
Mary A Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.6.9]
b. 25 Oct 1833 d. 30 Dec 1833
11
Henry F Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.6.10]
b. 2 Dec 1835 d. 28 Feb 1836
11
Anna Pleasant Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.6.11]
b. 20 Feb 1837 d. 6 Feb 1876
Benjamin F Whitner
b. 22 Feb 1835 d. 14 Jan 1919
12
Frank Church Whitner
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.6.11.1]
b. 11 Oct 1859 d. 20 Oct 1915
12
Annie Lee Whitner
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.6.11.2]
b. 3 Jan 1861 d. 31 Mar 1890
12
James Harrison Whitner
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.6.11.3]
b. 15 Aug 1862 d. 11 Feb 1926 [
=>
]
12
William Church Whitner
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.6.11.4]
b. 22 Sep 1864 d. 12 May 1940 [
=>
]
12
Elizabeth Whitner
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.6.11.5]
b. 5 Aug 1869 [
=>
]
12
Sarah Church Whitner
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.6.11.6]
b. 5 Aug 1869 d. 5 Dec 1873
12
Hugh Earle Whitner
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.6.11.7]
b. 3 Aug 1874 d. 8 Dec 1895
11
William Lee Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.6.12]
b. 21 Apr 1843 d. 31 Mar 1871
Laura Hynes Randolph
b. 12 Jul 1849 d. Oct 1881
12
Alonzo Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.6.12.1]
b. 27 Jun 1870 [
=>
]
10
Abigail Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.7]
b. Abt 1799
10
Elvira Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.8]
b. Abt 1801 d. Bef 21 Sep 1833
10
Rebecca Church
[1.1.4.1.3.2.3.2.4.9]
b. Abt 1803
9
Eleanor Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.5]
b. 10 Apr 1756 d. 28 Aug 1826
Simeon Nash
b. 15 May 1756 d. 20 Feb 1813
10
Timothy Nash
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.1]
b. 8 Sep 1779 d. 16 Sep 1779
10
Chester Nash
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.2]
b. 8 Oct 1780
+
Sabra Hasker
b. 1775 d. 7 Feb 1839
10
Guy Nash
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.3]
b. Abt 1783 d. 19 Aug 1825
Betsey Dart
b. 1783 d. 27 Feb 1813
11
Ambrose Nash
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.3.1]
b. 19 Dec 1810 d. 29 Mar 1813
11
Son Nash
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.3.2]
b. 26 Feb 1813
+
Rebecca Nash
b. 1783 d. 18 Jan 1818
+
Nancy Harrington
b. 1789 d. 16 May 1821
Ruth Hawks
b. 14 Jul 1786 d. 15 Aug 1825
11
James Rufus Nash
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.3.3]
b. 15 Aug 1823 d. 21 Mar 1907
Ursula Ann Blair
b. 13 Nov 1823 d. 26 Jun 1887
12
Frances Lorinda Nash
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.3.3.1]
b. 16 Aug 1847 d. 4 Mar 1929 [
=>
]
12
Walter Eugene Nash
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.3.3.2]
b. 21 Jul 1849 d. 24 Feb 1918 [
=>
]
12
Ellen Nash
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.3.3.3]
b. 1852
12
Eveline Manning Nash
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.3.3.4]
b. 25 Dec 1854 d. 14 Jan 1946 [
=>
]
12
Willis Nash
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.3.3.5]
b. 1857 [
=>
]
11
Abigail Hawkes Nash
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.3.4]
b. 17 Feb 1825 d. 1 Sep 1825
10
Louisa Nash
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.4]
b. 13 Mar 1788 d. 1850
Eldad Taylor
b. 26 Sep 1778 d. 1842
11
Ezra N Taylor
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.4.1]
b. 24 Mar 1810 d. 9 Apr 1810
11
Christopher C Taylor
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.4.2]
b. 3 Nov 1811 d. 1891
Margaret Jane Ketcham
b. 5 Jun 1832 d. 28 Apr 1909
12
Richard Taylor
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.4.2.1]
b. 1851
12
Dewit Taylor
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.4.2.2]
b. 1854
12
Maria Taylor
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.4.2.3]
b. 1860
12
Perry Taylor
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.4.2.4]
b. 1862
12
Edith Taylor
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.4.2.5]
b. 1866
12
Clara Taylor
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.4.2.6]
b. 1868
12
Alvah J Taylor
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.4.2.7]
b. Mar 1871 [
=>
]
11
Philo C Taylor
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.4.3]
b. 12 Mar 1818 d. Abt 1887
Mary Jane Buckland
b. 9 Jun 1821 d. 4 Feb 1886
12
Harriet E Taylor
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.4.3.1]
b. 9 Feb 1841 d. 28 Feb 1925 [
=>
]
12
Albert Taylor
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.4.3.2]
b. 27 Apr 1842 d. 4 May 1842
12
Cortez P Taylor
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.4.3.3]
b. 30 Jan 1845 d. 30 Oct 1930 [
=>
]
12
Eugene T Taylor
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.4.3.4]
b. 6 Nov 1847 d. 12 Sep 1865
12
Emma Ceola Taylor
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.4.3.5]
b. 21 May 1850 d. 26 Dec 1910 [
=>
]
12
Maria Jane Taylor
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.4.3.6]
b. 24 Aug 1857 d. 1874
12
Simeon Farlow Taylor
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.4.3.7]
b. 31 Mar 1866 d. Oct 1925
11
Anna Maria Taylor
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.4.4]
b. 15 Dec 1819 d. 26 Nov 1879
Alfred Farlow
b. 1 Sep 1821 d. 1 Jan 1895
12
Perry C Farlow
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.4.4.1]
b. 10 Dec 1842 d. 5 Feb 1863
12
Viola Farlow
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.4.4.2]
b. 17 Dec 1844 d. 1850
12
Simeon A Farlow
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.4.4.3]
b. 14 Feb 1847 d. 18 May 1915 [
=>
]
12
Nancy M Farlow
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.4.4.4]
b. 8 Jun 1849 d. 1933 [
=>
]
12
Stanley Farlow
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.4.4.5]
b. 8 Jun 1852 d. 8 Aug 1853
12
Wright Clifford Farlow
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.4.4.6]
b. 22 May 1855 d. 21 Mar 1925 [
=>
]
12
Belle Farlow
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.4.4.7]
b. 20 Mar 1858
12
Mary M Farlow
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.4.4.8]
b. 22 May 1860 d. 18 Jun 1928 [
=>
]
11
Stanley P Taylor
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.4.5]
b. 12 Mar 1822
11
Henry Hill Taylor
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.4.6]
b. 16 Oct 1825 d. 20 May 1882
Martha Elizabeth Emerick
b. 23 Aug 1828 d. 15 Nov 1916
12
Charles Simon Taylor
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.4.6.1]
b. 13 Oct 1851 d. 19 Jun 1913 [
=>
]
12
Jared W Taylor
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.4.6.2]
b. 11 Dec 1856
12
Elmer E Taylor
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.4.6.3]
b. 29 Jun 1861 d. 6 Feb 1862
12
Willard G Taylor
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.4.6.4]
b. 27 Apr 1868 d. 10 Sep 1868
11
Simeon N Taylor
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.4.7]
b. 10 Nov 1828
+
Charlotte E Taylor
b. Apr 1838
10
Simeon Nash, Jr
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.5]
b. 9 Dec 1790
+
Sarah Heaton
b. Abt 1810
10
Jared Nash
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.6]
b. 14 Jul 1793 d. 14 Feb 1831
Betsy Bassett
b. 23 Jun 1805 d. 10 Sep 1895
11
Eleanor Nash
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.6.1]
b. 1826
11
Nathan Bassett Nash
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.6.2]
b. 1830 d. 1910
Louisa Susan Gibson
b. 28 Mar 1837 d. 21 Jan 1929
12
Winfield Scott Nash
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.6.2.1]
b. 1860 d. 5 Jul 1947 [
=>
]
12
Anna A Nash
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.6.2.2]
b. 2 Oct 1862 d. 1 Apr 1942 [
=>
]
12
Orin Nash
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.6.2.3]
b. 1865 d. 1880
12
Beatrice Elizabeth Nash
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.6.2.4]
b. 29 Sep 1867
12
Simeon Nash
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.6.2.5]
b. 21 Sep 1870 d. 26 Jun 1948 [
=>
]
12
Charles B Nash
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.6.2.6]
b. 22 Jan 1874 d. 22 Sep 1960 [
=>
]
12
Walter F Nash
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.6.2.7]
b. 4 Jun 1876 d. 12 Nov 1963
10
Eleanor Nash
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.7]
b. 18 Aug 1796 d. 1849
10
Alfred Nash
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.8]
b. 5 Jul 1800 d. Aft 1888
Lucy Bigelow
b. 6 Apr 1808 d. 26 Mar 1834
11
Jane Eleanor Nash
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.8.1]
b. Abt 1821
Lorenzo Dow Minnick
b. 15 Feb 1819 d. 25 Mar 1892
12
Caroline Elizabeth Minnick
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.8.1.1]
b. 11 Nov 1852 d. 9 Jun 1916 [
=>
]
12
Herman Minnick
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.8.1.2]
b. 1854
12
Hiram Alfred Minnick
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.8.1.3]
b. 9 Jun 1855 d. 27 Oct 1935
11
Eleanor Jane Nash
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.8.2]
b. 24 Aug 1831 d. 31 Jul 1866
Hiram Marfet Nichols
b. 5 Sep 1823 d. 18 May 1849
12
Mary Jane Nichols
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.8.2.1]
b. 16 Oct 1849
11
Cynthia Janette
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.8.3]
b. 31 Jul 1832
11
Alfred Calvin
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.8.4]
b. 31 Jul 1833 d. 10 Feb 1834
Melissa Briggs
b. Abt 1820
11
Lucy Melissa Nash
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.8.5]
b. 25 Feb 1842 d. 29 Jul 1907
11
Alfred Darius Nash
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.8.6]
b. 4 May 1843
11
James Demerick Nash
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.8.7]
b. 8 Jul 1847
11
Emma Louisa Nash
[1.1.4.1.3.2.3.2.5.8.8]
b. 2 Apr 1849
9
Zipporah Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.6]
b. 17 Mar 1757 d. 12 Mar 1810
Joseph Bennett
b. 2 May 1731 d. 23 Apr 1837
10
Ralph Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.1]
b. 1778
10
Alfred Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.2]
b. 1780 d. 10 Mar 1861
10
Varney Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.3]
b. 1782
10
Zeporah Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.4]
b. 1783
10
Joseph Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.5]
b. 11 Sep 1788
Lucina Bonny
b. 28 Aug 1792
11
Louisa Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.5.1]
b. 8 Jun 1813 d. 31 Oct 1879
Abner Augustus Ames
b. 23 Nov 1799 d. 26 Sep 1850
12
Ralph Franklin Ames
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.5.1.1]
b. 28 Aug 1835 d. 19 Jan 1919 [
=>
]
12
Mary Elizabeth Ames
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.5.1.2]
b. 21 Dec 1839 d. 21 Jan 1911 [
=>
]
12
Janette Clarissa Ames
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.5.1.3]
b. 19 Aug 1841 d. Sep 1903 [
=>
]
12
Joseph Van Harmon Ames
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.5.1.4]
b. 22 Sep 1844 d. 1 May 1862
12
Olive Aurora Ames
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.5.1.5]
b. 22 Sep 1844 d. Apr 1849
12
Augustus Ames
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.5.1.6]
b. 1848 d. 1850
12
Jane Evaline Ames
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.5.1.7]
b. 1849 d. 1850
11
Lucinda A Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.5.2]
b. 16 May 1816 d. 14 Jun 1903
Charles Putnum
b. 24 Mar 1810 d. 16 Mar 1892
12
Lubin Augustus Putnam
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.5.2.1]
b. 1838 [
=>
]
12
Fernando Cortez Putnum
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.5.2.2]
b. 28 Feb 1844 d. 29 Sep 1913 [
=>
]
12
Charles C Putnum
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.5.2.3]
b. 13 May 1845 d. 2 Jan 1921
12
Elwood Putman
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.5.2.4]
b. 1849
12
Daniel Putnum
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.5.2.5]
11
George H Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.5.3]
b. 30 Mar 1818 d. 22 Oct 1886
Aurora Richardson
b. 1821 d. 17 Jun 1887
12
Son Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.5.3.1]
b. Abt 1846
12
Miranda Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.5.3.2]
b. Abt 1846 d. Abt 1865
12
Son Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.5.3.3]
b. 1848
11
Joseph Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.5.4]
b. 13 Jul 1819 d. 11 Apr 1883
+
Eliza
b. 1810 d. 20 Apr 1883
11
Varney E Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.5.5]
b. 10 Oct 1820 d. 6 Mar 1896
Jane Herrick
b. 15 Jun 1821 d. 24 Mar 1893
12
Dell Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.5.5.1]
b. 1848 d. 1918 [
=>
]
12
Jackson Adelbert Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.5.5.2]
b. 24 Dec 1850 d. 12 Sep 1938 [
=>
]
12
Elwood Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.5.5.3]
b. 3 Jan 1851 d. 30 Jun 1890 [
=>
]
12
Alfred Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.5.5.4]
b. 1857
12
Anna Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.5.5.5]
b. 1863
12
Gifford Allen Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.5.5.6]
b. 10 Jan 1863 d. 27 Jun 1916 [
=>
]
12
Dennis H Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.5.5.7]
d. 9 Jan 1940 [
=>
]
11
Sophia Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.5.6]
b. 17 Jun 1822
11
Josiah Hibbard Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.5.7]
b. 12 Jul 1824 d. 8 Mar 1904
11
Truman Sherman Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.5.8]
b. 28 Mar 1826 d. 26 Mar 1899
Huldah Edson
b. 26 Aug 1831 d. 6 Sep 1876
12
Horatio Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.5.8.1]
b. 26 May 1850 d. 1850
12
Ezra T Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.5.8.2]
b. 1 Jun 1851 d. 1851
12
Walter Ancil Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.5.8.3]
b. 11 May 1854 d. 27 Feb 1926 [
=>
]
12
Evaline Viola Bennet
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.5.8.4]
b. 24 Jan 1859 d. 20 May 1943 [
=>
]
12
Wellman George Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.5.8.5]
b. 28 May 1862 d. 21 Feb 1898 [
=>
]
12
Dolly Arluine Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.5.8.6]
b. 25 Sep 1865 d. 1 Jan 1899 [
=>
]
12
Lowell E Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.5.8.7]
b. 1 Jun 1868
11
Hannah Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.5.9]
b. 15 Jun 1829
10
Thankful Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.6]
b. 1791
10
William Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7]
b. 1795 d. 23 Jun 1863
Lydia Caryl
b. 24 Jan 1797 d. 1868
11
William Bennett, Jr
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.1]
b. Jan 1822 d. 1904
Hannah Jane Kibbe
b. 16 Sep 1832
12
Raymond A Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.1.1]
b. 12 Jan 1853 d. 6 Sep 1921
12
Finley Anson Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.1.2]
b. Aug 1854
12
Elva Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.1.3]
b. 1857 [
=>
]
12
Ada Fidelia Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.1.4]
b. 1861 [
=>
]
12
Emma Jane Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.1.5]
b. 10 Mar 1862 d. 25 Sep 1931
12
Henry E Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.1.6]
b. 1864 d. 1895 [
=>
]
12
Louisa Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.1.7]
b. 16 May 1870 d. 1930
11
Alonzo Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.2]
b. 10 Nov 1824 d. 2 Oct 1884
+
Maryette Moore
b. Abt 1824
Margaret Maxwell
b. 25 Sep 1835 d. 27 May 1915
12
Willis Lugene Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.2.1]
b. 8 Mar 1858 d. 2 Jun 1924 [
=>
]
12
Nettie Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.2.2]
b. 1859
12
Alpha Alonzo Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.2.3]
b. 26 May 1860 d. 21 Dec 1931 [
=>
]
12
Effie May Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.2.4]
b. Abt May 1862 d. 10 Dec 1943 [
=>
]
12
Margaret Emma Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.2.5]
b. 12 Aug 1862 d. 11 Jan 1915 [
=>
]
12
Albert D Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.2.6]
b. 1863 d. 19 May 1893
12
Dora Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.2.7]
b. 1866
12
Adelbert Glen Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.2.8]
b. 6 Sep 1869 [
=>
]
12
Minnie Adora Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.2.9]
b. 21 May 1871 d. 26 Jul 1939 [
=>
]
11
Anna Orpha Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.3]
b. 3 Sep 1826 d. 29 Aug 1909
Obed Rust
b. 22 Aug 1824 d. 30 Jun 1869
12
Caroline Rust
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.3.1]
b. 1848
12
Corodyne O Rust
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.3.2]
b. 26 Apr 1848 d. 27 Jun 1898 [
=>
]
12
Truman H Rust
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.3.3]
b. 1850
12
Eva L Rust
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.3.4]
b. 23 Dec 1852 d. 19 Aug 1911
12
Ida A Rust
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.3.5]
b. 27 Sep 1855 d. 6 Feb 1892 [
=>
]
12
Densie R Rust
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.3.6]
b. 20 Aug 1857
12
Carrie O Rust
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.3.7]
b. 20 Apr 1861 d. 9 Sep 1865
12
Harmon H Rust
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.3.8]
b. 1 May 1863 d. 3 Sep 1865
12
Ada W Rust
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.3.9]
b. 30 May 1865
12
Add W Rust
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.3.10]
b. 30 May 1865 d. 25 Sep 1919
12
Elisha D Rust
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.3.11]
b. 28 Oct 1868 d. 31 May 1929 [
=>
]
11
Arvilla Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.4]
b. Oct 1828 d. 28 Mar 1907
David C Hollis
b. Nov 1824 d. 9 Jun 1892
12
Albert A Hollis
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.4.1]
b. 6 Jun 1852 d. 11 Mar 1877 [
=>
]
12
Flora M Hollis
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.4.2]
b. 19 Jul 1853 d. 30 Apr 1879
12
Nettie E Hollis
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.4.3]
b. Mar 1856 d. 21 Aug 1858
12
Willie W Hollis
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.4.4]
b. Mar 1860 d. 6 Apr 1862
12
Nellie Arvilla Hollis
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.4.5]
b. May 1863 d. 2 Dec 1941 [
=>
]
11
Anson Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.5]
b. Nov 1830 d. 24 Apr 1905
Celia Eliza Durkee
b. 30 Apr 1838 d. 19 Mar 1926
12
John M Bennet
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.5.1]
b. Jun 1861 d. 10 Jun 1917
12
Lola M Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.5.2]
b. 1862 d. 20 Jun 1934
12
Ernest O Bennet
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.5.3]
b. 11 Jul 1872 d. 15 May 1945
11
Maria Lydia Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.6]
b. 14 Nov 1832 d. 8 May 1916
Albert F Horton
b. 21 Jul 1828 d. 8 Dec 1914
12
Franklin S Horton
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.6.1]
b. 21 May 1855 d. 27 Jul 1935 [
=>
]
12
Herbert Henry Horton
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.6.2]
b. Mar 1863 d. 10 May 1918 [
=>
]
12
Nora Horton
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.6.3]
b. 1866 d. 1957 [
=>
]
12
Albert F Horton, Jr
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.6.4]
b. 21 Feb 1868 d. 5 Jul 1938
12
Minnie Letty Horton
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.6.5]
b. 17 Dec 1869 d. 6 Jul 1964
12
Jennie A Horton
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.6.6]
b. Dec 1871 d. 1956 [
=>
]
12
Floyd Myron Horton
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.6.7]
b. May 1874 d. 18 May 1949
11
Elvira C Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.7]
b. 20 Feb 1835 d. 4 Nov 1905
Daniel Harris Crowningshield
b. 28 Oct 1827 d. 30 Nov 1911
12
Cordine H Crowningshield
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.7.1]
b. 1867
12
Theda Elnora "Nora" Crowningshield
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.7.2]
b. 10 Nov 1870 d. 18 Jan 1949 [
=>
]
11
Simon Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.8]
b. 1839 d. 8 Oct 1902
Alice Minerva Maxwell
b. Oct 1846 d. 29 Aug 1908
12
Ambers Simon "Ambrose" Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.8.1]
b. 10 Dec 1864 d. 8 Feb 1932 [
=>
]
12
Minerva May "Minnie" Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.8.2]
b. 4 Jul 1866 d. 29 Oct 1954 [
=>
]
12
Cora M Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.8.3]
b. Jan 1868 d. 29 Feb 1908
12
Myrtle Louella "Marties" Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.8.4]
b. 13 Oct 1872 d. 5 Dec 1944 [
=>
]
12
Llewellyn Merton "Mertie" Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.8.5]
b. 13 Oct 1872 d. 20 Dec 1940
12
William Henry Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.7.8.6]
b. 21 Sep 1875 d. 16 Mar 1925 [
=>
]
10
Polly Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.8]
b. 1797
10
Adin Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.9]
b. 1800 d. 6 May 1830
Angelina Houghton
b. 26 Aug 1801 d. 6 May 1891
11
Milo Pettibone Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.9.1]
b. 1821 d. 26 Feb 1844
11
Emery Seymoor Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.9.2]
b. 1823 d. 8 Dec 1825
11
Edwin Oscar Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.9.3]
b. 15 Dec 1824 d. 13 Sep 1901
11
Amelia Emeline Bennett
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.9.4]
b. 26 Oct 1827 d. 3 Feb 1918
Charles Parker
b. 1822 d. 25 Aug 1895
12
Esther Parker
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.9.4.1]
b. 1849
12
Mary Angeline Parker
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.9.4.2]
b. 3 May 1849 d. 14 Jun 1919 [
=>
]
12
Joseph Parker
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.9.4.3]
b. 1851
12
Charles E Parker
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.9.4.4]
b. 1851 d. 1852
12
Harry Elwood Parker
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.9.4.5]
b. 11 Jun 1853 d. 12 May 1933 [
=>
]
12
Grace E A Parker
[1.1.4.1.3.2.3.2.6.9.4.6]
b. 29 Jun 1860 [
=>
]
9
William Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.7]
b. 17 Feb 1763 d. 30 Oct 1848
Sophia Prouty
b. 5 Jun 1768 d. 22 Nov 1837
10
Dimmis Prouty Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1]
b. 18 Oct 1792 d. 22 Apr 1871
Sylvester Estabrook
b. 17 Apr 1790 d. 21 Dec 1859
11
William Whipple Estabrook
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.1]
b. 3 Nov 1811 d. 16 Feb 1898
Cynthia Barrett
b. 16 Jun 1817 d. 7 Jul 1863
12
Frederick Estabrook
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.1.1]
b. 1832
12
Jane M Estabrook
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.1.2]
b. 10 Mar 1834 d. 27 Apr 1907 [
=>
]
12
Ann Estabrook
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.1.3]
b. 1836
12
Whitemore Barrett Estabrook
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.1.4]
b. 2 Mar 1838 d. 7 May 1909 [
=>
]
12
Dwight Estabrook
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.1.5]
b. 1840
12
Elijah Estabrook
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.1.6]
b. 1843
12
Lovisa Estabrook
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.1.7]
b. 16 Jul 1845 d. 7 Jan 1917 [
=>
]
12
Willard Hiram Estabrook
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.1.8]
b. 30 Sep 1847 d. 17 Nov 1916 [
=>
]
12
Edgar Allison Estabrook
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.1.9]
b. 1850 d. 1920 [
=>
]
12
Lillie Estabrook
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.1.10]
b. 1855
12
Forrest Bernard Estabrook
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.1.11]
b. 11 Aug 1857 d. 9 Aug 1939 [
=>
]
12
Rolla Elroy Estabrook
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.1.12]
b. 1859 d. 1869
11
Rosannah Estabrook
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.2]
b. 18 Apr 1813 d. 17 Mar 1891
Nelson Charles Cole
b. 13 Feb 1813 d. 26 Jan 1890
12
George B Cole
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.2.1]
b. 22 Apr 1837 d. 29 Dec 1916 [
=>
]
12
Willard Cole
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.2.2]
b. 7 Jan 1841 d. 12 Feb 1845
12
Austin Benson Cole
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.2.3]
b. 5 Mar 1847 d. 12 Feb 1897 [
=>
]
12
Wilford R Cole
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.2.4]
b. 26 Apr 1851 d. 3 Aug 1890
12
William Armes Cole
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.2.5]
b. 26 Apr 1852 d. 1904 [
=>
]
12
Hattie R Cole
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.2.6]
b. 23 Jan 1855 d. 2 Jan 1929
11
John Estabrook
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.3]
b. 30 Jul 1815 d. 4 Dec 1873
Harriet G Post
b. 1832 d. Aug 1868
12
Sylvester David Estabrook
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.3.1]
b. 15 Jun 1854 d. 9 May 1909 [
=>
]
12
Albert Estabrook
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.3.2]
b. 1857 d. 19 Aug 1858
12
Agnes Estabrook
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.3.3]
b. May 1859 d. 5 Sep 1864
12
Charles Estabrook
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.3.4]
b. 1862 d. 20 May 1864
11
Sophia Estabrook
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.4]
b. 22 May 1817 d. 11 Jan 1898
Hiram Kittredge Russell
b. 13 Sep 1813 d. 25 Apr 1848
12
Charles Jeduthan Russell
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.4.1]
b. 11 Nov 1837 d. 31 Dec 1907 [
=>
]
George Mix Cole
b. 11 Feb 1824 d. 5 May 1897
12
Martin Cole
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.4.2]
b. 21 Sep 1861
12
Claire "Callie" Cole
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.4.3]
b. 1862
11
Elizabeth Estabrook
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.5]
b. 21 Oct 1820 d. 1858
11
Sylvester Hale Estabrook
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.6]
b. 8 Oct 1822 d. 24 Dec 1903
Lucy Lamb
b. 2 Sep 1826 d. 4 Jan 1886
12
Emma D Estabrook
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.6.1]
b. 17 Dec 1851 [
=>
]
12
John A Estabrook
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.6.2]
b. 29 Mar 1854 d. 23 Apr 1917
12
Sarah Elizabeth Estabrook
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.6.3]
b. 7 Jul 1856 d. 9 Oct 1927 [
=>
]
12
Lucy E Estabrook
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.6.4]
b. 7 Jun 1859
12
Almon S Estabrook
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.6.5]
b. 6 Feb 1868 d. 4 Dec 1874
12
Richard H Estabrook
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.6.6]
b. 9 Aug 1869 d. 16 Oct 1940 [
=>
]
+
Mary Eveline Gates
b. Jun 1842 d. 1901
11
Henry Estabrook
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.7]
b. 25 Nov 1824 d. 19 Mar 1891
Elizabeth Boyington Adams
b. 1833 d. 6 Feb 1881
12
Harry S Estabrook
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.7.1]
b. May 1859 d. 1932 [
=>
]
12
Grace Dickerson
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.7.2]
b. 1862
11
Sarah M Estabrook
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.8]
b. 11 Mar 1828 d. 6 Aug 1856
George Mix Cole
b. 11 Feb 1824 d. 5 May 1897
12
Flora Jeannette "Jenny" Cole
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.8.1]
b. 1852 d. 1934 [
=>
]
12
Charles M Cole
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.8.2]
b. 6 May 1855 d. 30 May 1941 [
=>
]
11
Harriet Estabrook
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.9]
b. 8 Nov 1829 d. 16 Sep 1897
George Washington Squires
b. 2 Jan 1828 d. 12 Mar 1907
12
Ora A Squires
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.9.1]
b. 22 Nov 1851 d. 22 Feb 1888 [
=>
]
12
William L Squires
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.9.2]
b. Sep 1855 [
=>
]
12
Eva Squires
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.9.3]
b. 1858 d. 1901 [
=>
]
12
Frank Lee Squires
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.9.4]
b. 5 Apr 1866 d. 22 Feb 1934 [
=>
]
12
Lewis B Squires
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.9.5]
b. 30 Jun 1872 d. 1 Feb 1952 [
=>
]
11
Warren Estabrook
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.10]
b. 2 Feb 1832
Eleanor A Dicker
b. Jun 1839 d. 15 Oct 1933
12
Albert G Estabrook
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.10.1]
b. 1866 d. 26 Sep 1896
12
George Warren Estabrook
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.10.2]
b. 10 Dec 1870 d. 1938 [
=>
]
12
Lena B Estabrook
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.10.3]
b. 28 Aug 1876 d. 11 Nov 1952 [
=>
]
11
Theodore H Estabrook
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.1.11]
b. 31 Dec 1837 d. 24 Dec 1899
10
William Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.2]
b. 17 Jan 1793 d. 25 Dec 1860
Nancy Carpenter
b. 25 Aug 1792 d. 12 Apr 1871
11
Martha Sophia Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.2.1]
b. 5 Aug 1828 d. 16 Mar 1863
Ezra P Willis
b. 1830 d. 5 Jun 1881
12
Augustus Willis
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.2.1.1]
b. 1852
12
James A Willis
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.2.1.2]
b. 28 Apr 1853 d. 27 Jun 1891
12
Elliot H Willis
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.2.1.3]
b. 8 Sep 1856 d. 16 May 1857
12
John A Willis
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.2.1.4]
b. 4 Mar 1860 d. 23 Apr 1926 [
=>
]
12
Male Willis
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.2.1.5]
b. 15 Mar 1863 d. 15 Mar 1863
11
Daniel Carpenter Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.2.2]
b. 10 May 1830 d. 10 Sep 1883
11
George Merlin Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.2.3]
b. 1831
10
Sophia Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.3]
b. 5 Oct 1794 d. 4 Jul 1868
Theodore Barnard Hoyt
b. 22 May 1786 d. 13 May 1874
11
Harriet Hoyt
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.3.1]
b. 10 Sep 1816 d. 6 Aug 1830
11
Richard Henry Hoyt
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.3.2]
b. 27 Dec 1820 d. 27 Jan 1909
Hannah Adaline Chapin
b. 23 Dec 1821 d. 15 Feb 1892
12
Harriet Isabelle Hoyt
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.3.2.1]
b. 31 May 1846 d. 17 Sep 1925 [
=>
]
12
Hannah Sophia Hoyt
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.3.2.2]
b. 22 Oct 1848 d. 12 Oct 1859
11
Hannah Hoyt
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.3.3]
b. 1822
11
Marietta Hoyt
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.3.4]
b. 4 Sep 1824 d. 18 Aug 1849
Thomas Williams Ashley
b. 18 Jan 1822 d. 24 Jan 1888
12
Lydia Sophia Ashley
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.3.4.1]
b. 6 Dec 1847
12
Marietta Ashley
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.3.4.2]
b. 1848 d. 3 Jun 1850
12
Son Ashley
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.3.4.3]
b. 6 Aug 1849 d. 6 Aug 1849
11
Jonathan Hoyt
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.3.5]
b. 20 Jun 1829 d. 3 Dec 1904
+
Harriet Vienna Willard
b. 1830 d. 25 Mar 1896
+
Laura Frances Poole
b. 1861 d. 1906
10
Elizabeth "Betsy" Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.4]
b. 9 Sep 1796
10
Lydia Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.5]
b. 2 Jun 1798
10
Timothy Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.6]
b. 19 Jan 1800 d. 1864
Theda Stoddard
b. 1812 d. 20 Dec 1859
11
Maria Theda Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.6.1]
b. 29 Nov 1833 d. 3 Dec 1916
Lewis H Hadley
b. 27 Jan 1817 d. 10 Apr 1886
12
Son Hadley
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.6.1.1]
b. 29 Dec 1863 d. 29 Dec 1863
11
Elijah Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.6.2]
b. 1835
11
John E Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.6.3]
b. Abt 1836
Hannah C Wood
b. 1838 d. 1875
12
Ida C Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.6.3.1]
b. Feb 1867 d. 16 Jan 1902 [
=>
]
12
Edwin Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.6.3.2]
b. 30 Dec 1870
12
Edward John Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.6.3.3]
b. 30 Dec 1874 d. 24 Dec 1956 [
=>
]
11
Mariet Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.6.4]
b. 1838
11
George Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.6.5]
b. 1841
10
Elijah Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.7.7]
b. 9 Apr 1801
9
John Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8]
b. 7 Feb 1765 d. 7 Nov 1830
Basmoth Hutchins
b. 7 Sep 1769 d. 9 Sep 1846
10
Betsy Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.1]
b. 25 Feb 1790 d. 7 Nov 1822
+
Daniel Taylor Aldrich
b. Oct 1796 d. 23 May 1857
10
John Whipple, Jr
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.2]
b. 11 Feb 1791 d. 2 Mar 1872
Margery Willard
b. 30 Nov 1794 d. 20 Jan 1869
11
Henry Willard Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.2.1]
b. 5 Jan 1812 d. 11 Mar 1889
Betsey Barrows
b. Abt 1813
12
Charles Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.2.1.1]
b. Abt 1832
12
Cynthia Jane Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.2.1.2]
b. 14 Jun 1835 d. 5 Nov 1874 [
=>
]
12
Orison Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.2.1.3]
b. 30 Mar 1842 d. 16 Feb 1905 [
=>
]
12
Elvira Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.2.1.4]
b. 15 Sep 1846 d. 8 Jul 1908 [
=>
]
12
Mary Rosetta Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.2.1.5]
b. 23 Jul 1848 d. 17 May 1901 [
=>
]
11
Sarah Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.2.2]
b. 23 Sep 1815 d. 18 Jan 1840
Orson Hogle
b. Abt 1814 d. Abt 1882
12
Helen Hogle
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.2.2.1]
b. 1836
12
Adeline Hogle
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.2.2.2]
b. 29 Nov 1838 d. 11 Apr 1918 [
=>
]
11
Elvira Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.2.3]
b. 3 Mar 1818 d. 9 Aug 1823
11
Eli Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.2.4]
b. 17 Oct 1820 d. 11 May 1904
Patience Foster
b. 5 May 1815 d. 17 Jan 1890
12
Ann Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.2.4.1]
b. 15 Mar 1842 d. 31 Dec 1927 [
=>
]
12
Marian Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.2.4.2]
b. 13 Mar 1845 d. 5 Jun 1901 [
=>
]
12
Arthur Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.2.4.3]
b. Aug 1848 d. Aug 1849
12
William Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.2.4.4]
b. Aug 1850 d. 16 Aug 1853
12
Patience Emma Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.2.4.5]
b. 4 Jul 1854 d. 16 Aug 1864
Mary Jane Legg
b. 18 Jan 1858 d. 2 Jul 1947
12
Elvira Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.2.4.6]
b. 6 Oct 1878 d. 29 Oct 1954 [
=>
]
12
James Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.2.4.7]
b. 30 Mar 1880 d. 28 Apr 1949 [
=>
]
12
Sarah Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.2.4.8]
b. 26 Oct 1881 d. 10 May 1882
12
Urilla Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.2.4.9]
b. 8 Apr 1883 d. 8 Nov 1960 [
=>
]
12
Mary Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.2.4.10]
b. 23 Oct 1885 d. 12 Dec 1887
12
George Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.2.4.11]
b. 30 Nov 1887 d. 4 Feb 1894
12
Edson Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.2.4.12]
b. 4 Aug 1889 d. 11 Nov 1964 [
=>
]
12
Iva Bell Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.2.4.13]
b. 7 Jun 1892 d. 9 Aug 1973 [
=>
]
12
William Wilford Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.2.4.14]
b. 9 Mar 1896 d. 25 Dec 1944 [
=>
]
Caroline Elida Lytle
b. 18 Apr 1840 d. 6 Dec 1912
12
Ivenette Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.2.4.15]
b. 3 Nov 1869 d. 13 Aug 1871
12
Eli Whipple, Jr
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.2.4.16]
b. 10 Dec 1871 d. 30 Mar 1937 [
=>
]
12
John Lytle Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.2.4.17]
b. 7 Apr 1874 d. 22 Dec 1966 [
=>
]
12
Willard Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.2.4.18]
b. 13 Mar 1876 d. 13 Jun 1877
12
Charles Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.2.4.19]
b. 22 Jan 1878 d. 22 Sep 1969 [
=>
]
12
Leah Caroline Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.2.4.20]
b. 12 Apr 1880 d. 14 Mar 1936 [
=>
]
12
Effie Christina Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.2.4.21]
b. 10 Aug 1882 d. 30 Oct 1967 [
=>
]
11
John Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.2.5]
b. 7 Jun 1823 d. 11 Feb 1837
11
Alfred Alonzo Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.2.6]
b. 26 Jun 1825 d. 20 Oct 1896
Esther Lilley
b. Abt 1825 d. Abt 1895
12
John C Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.2.6.1]
b. Jan 1847 bur. 7 Nov 1907 [
=>
]
12
Ivenetta Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.2.6.2]
b. Abt 1849
12
Sidney Orson Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.2.6.3]
b. 25 Aug 1851 d. 1911 [
=>
]
12
Seth A Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.2.6.4]
b. 20 Nov 1853 d. 13 Jan 1922
12
James Willard Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.2.6.5]
b. Abt 1857
12
Mary Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.2.6.6]
b. Abt 1858
12
Esther Isolina Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.2.6.7]
b. Abt 1861
12
Leroy E Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.2.6.8]
b. 28 Feb 1864 d. 20 Aug 1886
11
Mary Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.2.7]
b. 18 Feb 1829 d. 25 Dec 1858
+
Eugene Walker
b. Abt 1825 d. Abt 1897
10
Dimmis Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.3]
b. 26 Dec 1792 d. 2 Mar 1864
George Betterley
b. 31 Jul 1790 d. 16 Jul 1858
11
George Warren Betterley
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.3.1]
b. 27 Aug 1815 d. 24 Apr 1886
Ellen Sophie Betterley
b. 1 Dec 1816 d. 27 May 1894
12
Alfred A Betterley
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.3.1.1]
b. 4 Apr 1842 d. 31 May 1927
12
Ellen Calista Betterley
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.3.1.2]
b. 3 Apr 1852 d. 3 May 1858
12
George J Betterley
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.3.1.3]
b. 3 Apr 1852 d. 11 Dec 1928 [
=>
]
12
Philander Chester Betterley
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.3.1.4]
b. 5 May 1856 d. 16 Jun 1928 [
=>
]
11
John Whipple Betterley
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.3.2]
b. 1818 d. 1857
Matilda Merrill
b. 1820
12
John Washington Betterley
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.3.2.1]
b. Oct 1839 [
=>
]
12
Matilda Betterley
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.3.2.2]
b. 1843
12
Edson Betterley
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.3.2.3]
b. 1848
12
George Betterley
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.3.2.4]
b. 1849
11
Samuel Betterley
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.3.3]
b. 1820
Hannah Christiana Richmond
b. 4 Jun 1833 d. 7 Dec 1904
12
Fanny Jane Betterley
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.3.3.1]
b. 1853
12
William Betterly
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.3.3.2]
b. 1855
12
Mary Betterly
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.3.3.3]
b. 1859
12
Simeon Betterley
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.3.3.4]
b. 1865
12
George Betterly
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.3.3.5]
b. 1867 d. 1942 [
=>
]
12
Sarah Betterly
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.3.3.6]
b. 1871
11
Alfredo W Betterley
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.3.4]
b. 1824 d. 18 Jan 1880
Mary Crandall
b. 4 Feb 1829 d. 20 Dec 1852
12
Dennis R Betterley
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.3.4.1]
b. 1845
12
Carrie Dimmis Betterley
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.3.4.2]
b. 23 Oct 1845 d. 10 Aug 1920 [
=>
]
12
George Robert Betterley
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.3.4.3]
b. 26 Oct 1847 d. 24 Jan 1926 [
=>
]
Miranda Crandall
b. 6 Nov 1837 d. Jan 1909
12
Alfred Edison Betterly
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.3.4.4]
b. 21 Jan 1854 d. 28 Feb 1938 [
=>
]
12
William Henry Betterley
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.3.4.5]
b. 21 Feb 1857 d. 16 Jan 1929 [
=>
]
12
Frank Otis Betterley
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.3.4.6]
b. Mar 1859 d. 1944 [
=>
]
12
Byron Betterley
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.3.4.7]
b. 1865
12
Mary Betterley
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.3.4.8]
b. 22 Oct 1866 d. 19 Nov 1881
Frances E "Fannie" Taylor
b. Nov 1852 d. 1937
12
Amelia Cornelia Betterley
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.3.4.9]
b. 9 Jan 1873 d. 24 Mar 1957
12
Joseph Whipple Betterley
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.3.4.10]
b. 25 Jul 1875 d. 10 Aug 1965 [
=>
]
11
Laura C Betterley
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.3.5]
b. 6 Mar 1827 d. 26 Aug 1860
Timothy Crandall
b. 26 Oct 1826 d. 15 Nov 1908
12
Laura A Crandall
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.3.5.1]
b. Apr 1851 d. 12 Feb 1929 [
=>
]
12
Timothy Crandall
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.3.5.2]
b. 1852 d. 23 Jul 1921 [
=>
]
12
Irving Crandall
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.3.5.3]
b. 15 Nov 1853 d. 22 May 1929 [
=>
]
12
Joseph Harris Crandall
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.3.5.4]
b. 22 Feb 1856 d. 16 Mar 1882
12
Theressa Crandall
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.3.5.5]
b. 4 Aug 1858 d. 26 Jun 1895
11
Lydia Rozetta Betterley
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.3.6]
b. 17 May 1830 d. 2 Sep 1868
William W Oles
b. 1829 d. 24 Sep 1908
12
Maria Oles
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.3.6.1]
b. 1846
12
Myron Oles
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.3.6.2]
b. 1852 d. 26 Jun 1852
12
Clara M Oles
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.3.6.3]
b. 25 Jan 1854 d. 5 May 1935 [
=>
]
11
Lucie M Betterley
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.3.7]
b. 1833
John Youmans
b. 1830
12
Mary T Youmans
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.3.7.1]
b. 1854
11
William Ward Betterley
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.3.8]
b. 12 Nov 1835 d. Bef 6 Jul 1899
Amelia Mumford
b. 23 Jun 1840
12
William C Betterley
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.3.8.1]
b. Mar 1860 d. 1951
12
Arthur W Betterley
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.3.8.2]
b. 30 Jan 1862 d. 30 Aug 1938 [
=>
]
12
Alma G Betterley
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.3.8.3]
b. 1864
12
Mary Betterly
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.3.8.4]
b. Abt 1867
12
Cora Betterly
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.3.8.5]
b. 1868 d. Abt 1899
12
Clarence Betterly
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.3.8.6]
b. 1871
12
Cornelia Betterly
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.3.8.7]
b. Abt 1879
10
Polly Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.4]
b. 23 Dec 1794 d. 18 Oct 1876
Reuben Davis
b. 12 Sep 1781 bur. Feb 1842
11
Reuben Whipple Davis
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.4.1]
b. 1 Aug 1814
Sarah C Moore
b. 1820 d. 1860
12
Frank W Davis
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.4.1.1]
b. 8 Jun 1844 d. 11 Nov 1920 [
=>
]
12
Ella Davis
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.4.1.2]
b. Abt 1848 d. 1860
12
Fredrick G Davis
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.4.1.3]
b. 8 Aug 1851 d. 16 May 1936 [
=>
]
11
Mary Maria Davis
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.4.2]
b. 18 Feb 1817 d. 31 Mar 1865
+
Steaves Lockwood
b. 1815
11
Emily Jane Davis
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.4.3]
b. 2 Oct 1824
11
Laura Ann Davis
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.4.4]
b. 20 Mar 1828
11
Eliza Davis
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.4.5]
b. 1830
11
William Goodwin Davis
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.4.6]
b. 10 Jul 1832
11
Helen Davis
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.4.7]
b. 1835
11
Harvey W Davis
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.4.8]
b. 26 Aug 1839
10
Samuel Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.5]
b. 2 Oct 1796 d. 8 Jun 1867
Mercy Aldrich
b. Abt 1799 d. 12 Apr 1843
11
Maria M Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.5.1]
b. 8 Jul 1821 d. 23 Nov 1899
Rufus Curtis Phillips
b. 14 Mar 1819 d. 10 Dec 1862
12
Austin Phillips
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.5.1.1]
b. 1845
12
Lucinda Jane Phillips
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.5.1.2]
b. 15 Jun 1846 d. 10 Apr 1924 [
=>
]
12
Lorania Phillips
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.5.1.3]
b. 1849
12
Richard Melvin Phillips
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.5.1.4]
b. May 1849 d. 20 Jan 1922 [
=>
]
12
Lydia Phillips
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.5.1.5]
b. 1851 d. 16 Mar 1869
12
Sophronia Phillips
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.5.1.6]
b. 12 May 1853 d. 25 Mar 1891 [
=>
]
12
Harriet "Hattie" Phillips
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.5.1.7]
b. Jun 1853 d. 20 Sep 1933 [
=>
]
12
Lucy Phillips
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.5.1.8]
b. 1858
12
Robert Fulton Phillips
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.5.1.9]
b. 29 Mar 1859 d. 9 Jun 1932 [
=>
]
11
Jane E Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.5.2]
b. Abt 1833
Alford L Snyder
b. 19 Sep 1833 d. 3 Jun 1886
12
Charles L Snyder
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.5.2.1]
b. May 1859 d. 1937 [
=>
]
12
Frank L Snyder
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.5.2.2]
b. 1864 d. 1866
12
Willis Ellsworth Snyder
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.5.2.3]
b. 29 Apr 1867 d. 8 Apr 1931 [
=>
]
11
Lenoria D Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.5.3]
b. 31 Aug 1835 d. 23 May 1882
William James Powers
b. 27 Jun 1833 d. 1 Jul 1906
12
Abilene O Powers
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.5.3.1]
b. 24 Sep 1853 d. 11 Oct 1930 [
=>
]
12
William Powers
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.5.3.2]
b. 1858
12
Phineas Powers
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.5.3.3]
b. 1861 bur. 1892
12
Katie Powers
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.5.3.4]
b. Mar 1863 d. 28 Feb 1935
12
Lydia Powers
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.5.3.5]
b. 1865
12
Charles Powers
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.5.3.6]
b. 1868
12
Hannah Powers
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.5.3.7]
b. Abt May 1869
12
Frank Alfred Powers
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.5.3.8]
b. 1 Feb 1870 d. 24 Apr 1942 [
=>
]
12
Fred Aaron Powers
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.5.3.9]
b. 23 Jan 1872 d. 8 Mar 1954 [
=>
]
11
William W Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.5.4]
b. Oct 1837 d. 10 Jul 1928
+
Sarah J Adams
b. 1845 d. Bef 1900
+
Jane C Hower
b. Oct 1864 d. 23 Mar 1956
11
John Aldrich Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.5.5]
b. 11 Nov 1841 d. 6 Jun 1920
Mary Elizabeth Fowler
b. 29 Jan 1849 d. 20 Oct 1916
12
Frank Ernest Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.5.5.1]
b. 21 Apr 1870 d. 1961 [
=>
]
12
Eva A Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.5.5.2]
b. 13 Jan 1875 [
=>
]
12
Arthur E. Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.5.5.3]
b. 6 Dec 1876
Orpha Ann Dietzman
b. 6 Nov 1860 d. 4 Feb 1928
12
Beulah Ellen Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.5.5.4]
b. 26 Aug 1887 d. 10 Sep 1962 [
=>
]
12
Jennie Elizabeth Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.5.5.5]
b. 11 May 1890 d. 7 May 1971 [
=>
]
12
Winifred Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.5.5.6]
b. 2 Oct 1898 d. 28 Mar 1903
Nancy Lafferty
b. 1819 d. Aft Jun 1880
11
Harriett Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.5.6]
b. 1845
10
Alfred Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.6]
b. 14 Sep 1798 d. 2 Jun 1872
Clarissa Mary Cheney
b. 14 Aug 1799 d. 14 Apr 1885
11
Alfred Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.6.1]
b. 20 Apr 1836 d. 13 Apr 1906
Lovinda Johnson
b. 1843 d. 8 Feb 1879
12
Carrie Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.6.1.1]
b. Abt 1861 d. 1954 [
=>
]
12
John B Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.6.1.2]
b. 10 Sep 1862 d. 1 Jul 1880
12
Mary Emma Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.6.1.3]
b. Jan 1866 [
=>
]
12
Alvira Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.6.1.4]
b. May 1866 d. 1929 [
=>
]
12
William Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.6.1.5]
b. Jul 1868 [
=>
]
12
Mary Minnie Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.6.1.6]
b. Aug 1870 d. Sep 1904 [
=>
]
12
Julia Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.6.1.7]
b. 1 Jul 1872 d. 24 Aug 1872
12
Rhoda Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.6.1.8]
b. Abt 1874
12
Charles Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.6.1.9]
b. Abt 1877 [
=>
]
+
Mary Ada Frances Ackeley
b. 31 Aug 1854 d. 5 Jan 1913
10
Laura Ann Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.7]
b. 29 Apr 1803 d. 12 Mar 1860
Daniel Taylor Aldrich
b. Oct 1796 d. 23 May 1857
11
Daniel Lyman Aldrich
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.7.1]
b. 6 Jan 1826 d. 22 Sep 1876
+
Electa R Phippen
b. 23 Apr 1830 d. 3 Oct 1868
11
Albert Myron Aldrich
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.7.2]
b. 10 May 1827 d. 2 May 1899
Mary Ann Laws
b. 1832 d. 6 Nov 1897
12
George Albert Aldrich
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.7.2.1]
b. 31 Aug 1858 d. 14 Dec 1929 [
=>
]
12
Alfred Hosea Aldrich
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.7.2.2]
b. 12 Apr 1862 d. 15 Jan 1923 [
=>
]
12
Harry Lincoln Aldrich
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.7.2.3]
b. 14 Nov 1865
12
Jennie May Aldrich
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.7.2.4]
b. 2 Nov 1868 d. 29 Feb 1936 [
=>
]
+
Frances Annie Teakles
b. 20 Jun 1856 d. 11 Nov 1940
11
Henry Newell Aldrich
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.7.3]
b. 4 Oct 1829 d. 19 Dec 1894
Lucy Melvina Butterfield
b. Abt 1829 d. 28 Sep 1864
12
Henry Harrison Aldrich
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.7.3.1]
b. 17 Feb 1856 d. 4 Jan 1914
12
Laura Melvina Aldrich
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.7.3.2]
b. 5 Mar 1858 d. 2 Jan 1928 [
=>
]
12
Moses Lyman Aldrich
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.7.3.3]
b. 28 Oct 1861 d. 14 Dec 1936 [
=>
]
12
Florence Aurilla Aldrich
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.7.3.4]
b. 12 Oct 1863 d. 13 Oct 1927 [
=>
]
Sylvia Eliza Chamberlain
b. Abt 1840 d. 27 Jun 1875
12
Daughter Aldrich
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.7.3.5]
b. 4 Jun 1874 d. 4 Jun 1874
11
Ambrose Aldrich
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.7.4]
b. 1831 d. 25 Jan 1885
+
Annie M Dean
b. 1834 d. 12 Jul 1861
Perryntha Tuttle Davis
b. 27 Jan 1835 d. 30 Mar 1915
12
Anne L Aldrich
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.7.4.1]
b. 1859
12
Ambrose D Aldrich
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.7.4.2]
b. 1865
12
Elizabeth Frances Aldrich
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.7.4.3]
b. Mar 1870 d. 24 Oct 1959 [
=>
]
12
Charlotte Tuttle Aldrich
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.7.4.4]
b. 28 Oct 1872 d. 18 Feb 1874
12
Emma Whipple Aldrich
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.7.4.5]
b. 1875 d. 4 Aug 1875
12
May Frothingham Aldrich
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.7.4.6]
b. 13 May 1875
11
John Whipple Aldrich
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.7.5]
b. 14 Nov 1833 d. 14 Feb 1891
Hannah Maria Fitch
b. 4 Sep 1834 d. 5 Apr 1896
12
Laura A Aldrich
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.7.5.1]
b. 16 Mar 1861 d. 30 Apr 1934 [
=>
]
12
John Whipple Aldrich
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.7.5.2]
b. 25 Jul 1867
11
Laura Ann Aldrich
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.7.6]
b. 16 Apr 1836 d. 9 Sep 1860
Marshall N Houghton
b. Abt 1827 d. 27 Jul 1904
12
Herbert Marshall Houghton
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.7.6.1]
b. 25 Apr 1860 d. 6 Apr 1903 [
=>
]
11
Aaron Robinson Aldrich
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.7.7]
b. 5 Jul 1837
+
Abigail A Harris
b. 1844
11
Harrison Aldrich
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.7.8]
b. 10 Sep 1840 d. 5 Sep 1909
Helen Louisa Morse
b. 6 Jun 1841 d. 1 Nov 1925
12
Minnie Aldrich
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.7.8.1]
b. 25 Aug 1865 d. 11 Jan 1868
12
Helen Edith Aldrich
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.7.8.2]
b. 14 Jun 1877 d. 18 Jan 1916 [
=>
]
10
Edson Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8]
b. 5 Feb 1805 d. 11 May 1894
Lavina Goss
b. 7 Jul 1811 d. 13 Sep 1846
11
Maria Blanche Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.1]
b. 15 Feb 1845 d. 8 Dec 1846
Mary Ann Yeager
b. 1 Nov 1823 d. 26 Mar 1877
11
Mary Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.2]
b. 1849 d. Bef 1860
11
John Dagbert Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.3]
b. 27 Oct 1851 d. 28 Mar 1898
Caroline Monroe Wallace
b. 10 Aug 1856 d. 27 Nov 1882
12
Lavinia Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.3.1]
b. 24 Nov 1882 d. 25 Nov 1882
Sabina Clark Adams
b. 19 Aug 1865 d. 7 Dec 1887
12
Oliver Dagbert Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.3.2]
b. 12 Nov 1886 d. 27 Feb 1889
Charity Melissa Faith Adams
b. 25 Dec 1868 d. 30 Jan 1964
12
Raymond Homer Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.3.3]
b. 31 Aug 1889 d. 24 Jun 1970 [
=>
]
12
Vivian Earl Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.3.4]
b. 5 Feb 1891 d. 7 Jul 1983 [
=>
]
11
William Mickle Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.4]
b. 12 Mar 1854 d. 31 Aug 1918
Polly Ann Carter
b. 29 Dec 1857 d. 24 Aug 1931
12
William Dominicus Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.4.1]
b. 25 Apr 1877 d. 20 Nov 1927 [
=>
]
12
Orson Yeager Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.4.2]
b. 7 Jul 1879 d. 7 Nov 1893
12
Frank Behan Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.4.3]
b. 22 Jul 1882 d. 10 Mar 1887
12
Albert Carter Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.4.4]
b. 20 Jul 1886 d. 18 Mar 1887
12
Anna Laura Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.4.5]
b. 11 Jun 1888 d. 27 Nov 1901
12
Leland Stanford Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.4.6]
b. 9 Sep 1892 d. 2 Jul 1911
12
Flossie Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.4.7]
b. 21 Dec 1894 d. 15 Mar 1990 [
=>
]
12
Dawn Zenith Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.4.8]
b. 18 Sep 1897 d. 18 Jun 1898
12
Violet Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.4.9]
b. 18 Dec 1899 d. 6 Sep 1984 [
=>
]
11
Joseph Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.5]
b. 8 Dec 1856 d. 8 Dec 1856
11
Mary Ann Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.6]
b. 4 Mar 1859 d. 23 May 1919
Ezra Curtis
b. 13 Aug 1854 d. 24 Feb 1925
12
Dagbert Edson Curtis
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.6.1]
b. 27 May 1878 d. 6 Dec 1883
12
William Ezra Curtis
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.6.2]
b. 14 Jul 1880 d. 22 Aug 1935 [
=>
]
12
Willis Sidney Curtis
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.6.3]
b. 14 Jul 1880 d. 13 Jul 1918
12
LeRoy Curtis
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.6.4]
b. 25 Oct 1882
12
Adelia Curtis
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.6.5]
b. 9 Feb 1885 d. 27 Jun 1898
12
Blanche Curtis
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.6.6]
b. 19 Aug 1887 d. 28 Jul 1978 [
=>
]
12
Sterling Curtis
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.6.7]
b. 10 Jan 1890 d. 3 Sep 1954 [
=>
]
12
Martha Curtis
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.6.8]
b. 27 Mar 1892 d. 19 Oct 1980 [
=>
]
12
Lavinia Curtis
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.6.9]
b. 20 Dec 1893 d. 26 Apr 1979 [
=>
]
12
Carter Curtis
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.6.10]
b. 10 Jan 1897 d. 1 Dec 1918
12
Orson Curtis
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.6.11]
b. 27 Sep 1899 d. 31 May 1979
12
Lealeth Mildred Curtis
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.6.12]
b. 16 Mar 1903 d. 6 Apr 1954 [
=>
]
11
Laura Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.7]
b. 23 Sep 1861 d. 17 Jul 1935
+
Joshua Parshall Terry
b. 3 Apr 1860 d. 6 Dec 1941
George Timothy Holdaway
b. 4 Dec 1854 d. 25 May 1929
12
George Lynn Holdaway
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.7.1]
b. 25 Oct 1881 d. 23 Jan 1939 [
=>
]
12
Katie Elnora Holdaway
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.7.2]
b. 25 Jun 1884 d. 30 Jan 1889
12
Hugh Holdaway
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.7.3]
b. 19 Aug 1886 d. 2 Mar 1970 [
=>
]
12
Etta Holdaway
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.7.4]
b. 5 Jan 1889 d. 4 Sep 1971 [
=>
]
12
Fredonia Holdaway
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.7.5]
b. 30 Dec 1890 d. 30 Aug 1954 [
=>
]
12
Laura May Holdaway
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.7.6]
b. 12 Jan 1893 d. 2 Sep 1893
12
Mary Unita Holdaway
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.7.7]
b. 14 Apr 1895 d. 10 Apr 1922
12
Reed Holdaway
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.7.8]
b. 12 Dec 1898 d. 26 Aug 1939 [
=>
]
12
Jean Holdaway
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.7.9]
b. 26 May 1902 d. 8 Jan 1906
Harriet Yeager
b. 15 Jul 1826 d. 3 Jul 1901
11
Ann Walrade Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.8]
b. 7 Jul 1851 d. 9 Dec 1927
Hans Peter Rasmussen
b. 24 Jul 1850 d. 5 Dec 1933
12
Minnie Leoma Bilby
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.8.1]
b. 13 Aug 1875 d. 27 Aug 1957 [
=>
]
12
Harriet Ann Bilby
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.8.2]
b. 3 Apr 1877 d. 8 Apr 1918 [
=>
]
12
Blanche Walrade Bilby
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.8.3]
b. 27 Apr 1887 d. 2 May 1975 [
=>
]
12
John Charles Bilby
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.8.4]
b. 23 Sep 1889 d. 24 Sep 1894
12
Ralph Willard Bilby
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.8.5]
b. 15 Sep 1891 d. Sep 1984 [
=>
]
12
Edson Stanton Bilby
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.8.6]
b. 17 Jun 1893 d. 11 Oct 1965
12
Annie Lucinda Farley
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.8.7]
b. 17 Nov 1901 d. 17 Jun 1947 [
=>
]
11
Edson Kimball Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.9]
b. 10 Oct 1852 d. 18 Feb 1855
11
Lavinia Goss Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.10]
b. 26 Apr 1854 d. 21 Feb 1855
11
Edson Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.11]
b. 18 Dec 1855 d. 4 Apr 1933
Rowena Celestia McFate
b. 14 Nov 1867 d. 8 Jul 1942
12
Lucy Olive Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.11.1]
b. 21 Feb 1885 d. 5 Apr 1913 [
=>
]
12
Lavinia Goss Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.11.2]
b. 26 Aug 1886 d. 7 Jun 1888
12
Joseph Edson Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.11.3]
b. 27 Apr 1888 d. 5 Sep 1948 [
=>
]
12
William Mickel Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.11.4]
b. 20 Jul 1890 d. 20 Jul 1918
12
Levi Lisk Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.11.5]
b. 29 Apr 1892 d. 4 Jan 1908
12
John Lowell Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.11.6]
b. 9 Mar 1894 d. 1 Jul 1920
12
Columbus Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.11.7]
b. 29 Feb 1896 d. 10 Mar 1990 [
=>
]
12
Ammon Mishic Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.11.8]
b. 14 Dec 1897 d. 28 May 1926 [
=>
]
12
Rowena Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.11.9]
b. 27 Aug 1899 d. 22 Oct 1900
12
Reed Yeager Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.11.10]
b. 15 Jun 1901 d. 19 Apr 1961 [
=>
]
12
Forrest Floyd Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.11.11]
b. 31 Mar 1903 d. 13 Oct 1996 [
=>
]
12
Hugh Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.11.12]
b. 26 Apr 1905 d. 11 Feb 1985
12
Walrade Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.11.13]
b. 5 Feb 1907 d. 2 Oct 1963 [
=>
]
12
Ecco Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.11.14]
b. 20 Apr 1909 d. 5 Apr 1973 [
=>
]
12
Lyle Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.11.15]
b. 3 Mar 1911 d. 1 Jan 1987 [
=>
]
12
Lester Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.11.16]
b. 3 Mar 1911 d. 3 Aug 1911
11
Willard Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.12]
b. 16 Mar 1858 d. 5 Apr 1941
Emma Melissa Oliver
b. 21 Sep 1867 d. 29 Aug 1948
12
Joseph Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.12.1]
b. 29 Aug 1885 d. 29 Aug 1885
12
Lydia Emma Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.12.2]
b. 16 Feb 1887 d. 26 Oct 1977 [
=>
]
12
Willard Whipple, Jr
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.12.3]
b. 15 Aug 1888 d. 20 Dec 1949 [
=>
]
12
Harriet Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.12.4]
b. 23 Mar 1890 d. 24 Mar 1956 [
=>
]
12
Nancy Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.12.5]
b. 3 Jun 1892 d. 16 Mar 1971 [
=>
]
12
Laura Walrade Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.12.6]
b. 31 May 1895 d. 7 Jun 1897
12
Oliver Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.12.7]
b. 22 Jan 1898 d. 30 Jan 1898
12
Alzada Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.12.8]
b. 5 Apr 1899 d. 29 Sep 1986 [
=>
]
12
Anne Julia Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.12.9]
b. 31 Jan 1902 d. 11 Dec 1974
12
Orson Temple Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.12.10]
b. 19 May 1904 d. 25 Aug 1964
12
Charles Chester Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.12.11]
b. 16 Oct 1906 d. 12 Jul 1995 [
=>
]
12
Howard Eugene Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.12.12]
b. 5 Jan 1909 d. 5 Sep 1964 [
=>
]
12
Milton Lloyd Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.12.13]
b. 15 Jun 1911 d. 7 Mar 1987 [
=>
]
12
Melvin Floyd Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.12.14]
b. 15 Jun 1911 d. 28 Jun 1977 [
=>
]
11
Harriet Julia Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.13]
b. 10 Mar 1860 d. 28 Aug 1869
11
Brigham Young Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.14]
b. 27 Aug 1861 d. 22 Feb 1950
Sarah Davis Hawkins
b. 21 Mar 1872 d. 25 Nov 1918
12
Brigham Charles Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.14.1]
b. 15 Oct 1890 d. 25 Apr 1892
12
Sarah Geneva Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.14.2]
b. 6 Jan 1893 d. 7 Sep 1975 [
=>
]
12
Willard Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.14.3]
b. 10 Apr 1895 d. 23 May 1981 [
=>
]
12
Florence Vivian Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.14.4]
b. 22 Nov 1897 d. 10 Jul 1899
12
Welcome Unita Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.14.5]
b. 3 Feb 1900 d. 19 Jan 1903
12
Evalina Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.14.6]
b. 7 Aug 1902 d. 9 Aug 1976 [
=>
]
12
Edson Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.14.7]
b. 27 Jan 1905 d. 13 Feb 1905
12
Joseph Leo Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.14.8]
b. 10 May 1908 d. 18 Jul 1986
11
Charles Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.15]
b. 9 Sep 1863 d. 13 Apr 1919
Anna Catherine Hansen
b. 5 Sep 1871 d. 25 Oct 1962
12
Jennie May Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.15.1]
b. 11 Jun 1890 d. 19 Dec 1976 [
=>
]
12
Pearl Wallrade Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.15.2]
b. 17 Jan 1893 d. 8 May 1979 [
=>
]
12
Charles Hansen Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.15.3]
b. 4 Oct 1895 d. 2 Jan 1984
12
Edson L Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.15.4]
b. 28 Mar 1898 d. 12 Feb 1972 [
=>
]
12
Cleah Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.15.5]
b. 10 Nov 1900 d. 31 Mar 1990 [
=>
]
12
Clyde Anthony Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.15.6]
b. 18 Sep 1903 d. 26 May 1938
12
Augustus Leon Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.15.7]
b. 14 Jan 1906 d. 13 Mar 1997 [
=>
]
12
Marva Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.15.8]
b. 14 Feb 1909 d. 6 Mar 2001 [
=>
]
12
Annie Catherine Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.15.9]
b. 19 Jul 1911 d. 29 Jun 1992 [
=>
]
Mary Louisa Walser
b. 20 Nov 1877 d. 6 Mar 1918
12
John Jacob Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.15.10]
b. 3 Apr 1899 d. 10 Jul 1957 [
=>
]
12
Leah Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.15.11]
b. 29 Nov 1900 d. 13 Dec 1900
12
William Carlos Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.15.12]
b. 14 Dec 1901 d. 22 Oct 1902
12
Mary Louisa Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.15.13]
b. 31 Aug 1903 d. 8 Aug 1973 [
=>
]
12
Harriet Ann Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.15.14]
b. 4 Dec 1905 d. 22 Nov 1986 [
=>
]
12
Marvin Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.15.15]
b. 14 Feb 1909 d. 21 Jan 1913
12
Ruth Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.15.16]
b. 27 Dec 1910 d. 16 Sep 1994 [
=>
]
12
Eva Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.15.17]
b. 11 Jan 1913 d. 27 Jun 1989
12
Waldo Walser Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.15.18]
b. 4 Jun 1915 d. 4 Oct 1919
12
Alma Virgil Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.15.19]
b. 20 Sep 1917 d. 12 Mar 1971 [
=>
]
11
Lavinia Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.16]
b. 22 May 1865 d. 28 Aug 1869
11
Harry Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.17]
b. 1 Jun 1869 d. 10 Jun 1896
+
Lynda Flint
b. 23 Aug 1793 d. 1855
Amelia Maria Fellows
b. 13 May 1838 d. 4 Jul 1890
11
Albert Fellows Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.18]
b. 10 Nov 1856 d. 13 Jul 1907
Mariah Elizabeth Carter
b. 27 Feb 1856 d. 12 Sep 1907
12
Carrie Elizabeth Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.18.1]
b. 12 Dec 1877 d. 21 Nov 1963 [
=>
]
12
Enos Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.18.2]
b. 17 Mar 1881 d. 17 Aug 1901
12
Bertha Violet Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.18.3]
b. 31 Oct 1884 d. 6 May 1961
12
Jessie Maria Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.18.4]
b. 5 Dec 1895 d. 19 Jun 1896
12
Dewey Albert Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.18.5]
b. 29 Nov 1897 d. 25 Oct 1984 [
=>
]
11
Emeline Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.19]
b. 17 Mar 1858 d. 10 Mar 1924
Moroni Rone Adair
b. 31 Oct 1855 d. 18 Feb 1916
12
Edson Jefferson Adair
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.19.1]
b. 12 Apr 1887 d. 2 Feb 1969 [
=>
]
12
Dagbert Moroni Adair
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.19.2]
b. 8 Mar 1888 d. 14 May 1952 [
=>
]
12
Albert D Adair
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.19.3]
b. 12 Nov 1891 d. 5 Jan 1900
+
David A Lindsay
b. 26 Jul 1866 d. 1 Jul 1935
+
John Carvel Tyler
b. Abt 1854
Edmund Durfee Carter
b. 2 Mar 1854 d. 28 Mar 1915
12
LeRoy Carter
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.19.4]
b. 5 Jan 1875 d. 10 Feb 1935 [
=>
]
12
Addie Eliza Carter
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.19.5]
b. 22 Apr 1878 d. 20 Apr 1963 [
=>
]
12
Guy L Carter
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.19.6]
b. Aug 1891 d. 9 Oct 1891
11
Richard Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.20]
b. 11 Jun 1860 d. 16 Sep 1876
11
Heber Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.21]
b. 26 Mar 1862 d. 19 Mar 1877
11
Alice Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.22]
b. 23 Mar 1864 d. 3 Feb 1880
11
Amelia Minerva Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.23]
b. 23 Jun 1865 d. 27 Jan 1919
John Campbell Tyler
b. 1 Sep 1857 d. 28 Jan 1951
12
William Albert Tyler
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.23.1]
b. 14 Mar 1884 bur. Mar 1954 [
=>
]
12
Alice Minerva Tyler
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.23.2]
b. 15 Jul 1887 d. 10 Sep 1978
12
Mary Mariah Tyler
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.23.3]
b. 13 Mar 1890 d. 30 Apr 1981
12
Ida Vilate Tyler
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.23.4]
b. 15 Sep 1892 d. 26 Dec 1959
12
Eva Marie Mack Tyler
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.23.5]
b. 27 Jul 1898 d. 31 Aug 1985 [
=>
]
12
Mancraba Tyler
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.23.6]
b. 15 Jul 1900 d. 16 Jul 1900
11
Vilate Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.24]
b. 8 Dec 1868 d. 9 Jul 1891
Ephriam Penrod
b. 17 Sep 1866 d. 10 May 1935
12
Lee Ephraim Penrod
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.24.1]
b. 22 Jan 1887 d. 10 Oct 1928 [
=>
]
12
Vilate Basmuth Penrod
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.24.2]
b. 10 Feb 1889 d. Oct 1900
12
Bessie Vilate Penrod
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.24.3]
b. 11 Feb 1889 d. 28 Dec 1901
11
Hyrum Hanford Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.25]
b. 20 Jan 1871 d. 17 Jul 1949
Laura Catherine McClellan
b. 9 Jun 1873 d. 8 Dec 1895
12
Lula Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.25.1]
b. 11 Mar 1893 d. 1 Jul 1985 [
=>
]
12
Clella Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.25.2]
b. 26 Jun 1895 d. 17 Jun 1938 [
=>
]
Effie Ecco Tenney
b. 6 Oct 1887 d. 12 Jun 1914
12
Genevieve Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.25.3]
b. 1 Jun 1912 d. 26 Apr 2008 [
=>
]
12
Effie Ecco Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.25.4]
b. 3 Jun 1914 d. 18 Sep 1914
+
Lucretia Black
b. 19 Aug 1883 d. 15 Dec 1949
+
Elsie McClellan
b. 1874
11
David E Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.26]
b. 20 Jan 1873 d. 1881
11
Ida Rosetta Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.27]
b. 29 Mar 1876 d. 15 Jul 1943
John Jacob Walser
b. 7 Jul 1872 d. 3 Aug 1962
12
Clessa May Walser
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.27.1]
b. 5 May 1895 d. 6 Sep 1985 [
=>
]
12
Amelia Walser
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.27.2]
b. 13 Jan 1898 d. 6 Mar 1929 [
=>
]
12
Ida Walser
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.27.3]
b. 12 Jan 1900 d. 22 Apr 1988 [
=>
]
12
Anna Laura Walser
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.27.4]
b. 19 Jan 1902 d. 1 Feb 1999 [
=>
]
12
John Floyd Walser
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.27.5]
b. 29 Jan 1904 d. 15 Jan 1992 [
=>
]
12
Erma Walser
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.27.6]
b. 2 Apr 1907 d. 31 Jan 1983
12
Elizabeth Walser
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.27.7]
b. 9 Sep 1910 d. 10 Jul 2003
12
Lucille Walser
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.27.8]
b. 16 Dec 1911 d. 11 May 1913
12
Frank Leroy Walser
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.27.9]
b. 4 Oct 1913 d. 9 Nov 1934
12
Wilma Reah Walser
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.27.10]
b. 3 May 1917 d. 20 Jun 1987 [
=>
]
11
Alfred Safford Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.28]
b. 10 Jul 1879 d. 3 Jul 1890
11
Elizabeth Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.29]
b. 18 Jul 1883 d. 3 Aug 1884
Mary Ann Quinney
b. 8 May 1832 d. 1 Dec 1910
11
Mary Unita Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.30]
b. 26 Jan 1858 d. 15 Feb 1920
Enos Curtis Carter
b. 28 Mar 1854 d. 7 Feb 1938
12
Archie Bell Carter
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.30.1]
b. 24 Sep 1876 d. 6 Jan 1902 [
=>
]
12
Guy Lee Carter
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.30.2]
b. 3 Dec 1879 d. 9 Oct 1891
12
Jeanette Rebecca Carter
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.30.3]
b. 24 Mar 1882 d. 5 Jul 1947 [
=>
]
12
Nina Carter
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.30.4]
b. 16 Mar 1884 d. 2 Jun 1965 [
=>
]
12
Ray Whipple Carter
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.30.5]
b. 10 Feb 1890 d. 5 Jul 1969 [
=>
]
12
Ora Dell Carter
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.30.6]
b. 21 Apr 1898 d. 1995 [
=>
]
12
Flora Belle Carter
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.30.7]
b. 21 Apr 1903 d. 30 May 1987 [
=>
]
11
Blanche Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.31]
b. 20 Feb 1861 d. 14 Dec 1936
William Heber Stubbs
b. 1 Dec 1855 d. 24 Oct 1937
12
Blanche Elsie Stubbs
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.31.1]
b. 12 Jan 1881 d. 10 Nov 1961 [
=>
]
12
Mary Ellender Stubbs
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.31.2]
b. 15 Feb 1883 d. 6 Jul 1940 [
=>
]
12
William Heber Stubbs
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.31.3]
b. 13 Jun 1886 d. 3 Apr 1888
12
Ralph Richard Stubbs
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.31.4]
b. 27 Nov 1889 d. 8 Apr 1965
12
Hazel Dell Stubbs
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.31.5]
b. 31 May 1892 d. 19 Apr 1976 [
=>
]
12
Edson Leroy Stubbs
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.31.6]
b. 30 Sep 1894 d. 19 Feb 1980 [
=>
]
12
Donald H Stubbs
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.31.7]
b. 9 Jul 1898 d. 25 Jul 1968 [
=>
]
12
Rual S Stubbs
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.31.8]
b. 3 Mar 1902 d. 3 Mar 1902
11
Matilda Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.32]
b. 19 Jun 1866 d. 25 Mar 1947
John Edward Cook
b. 5 Aug 1860 d. 25 Nov 1940
12
Mervin Luke Cook
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.32.1]
b. 14 Feb 1891 d. 29 Jun 1953 [
=>
]
12
Owen Edward Cook
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.32.2]
b. 15 Jul 1893 d. 8 Nov 1918
12
John McKinley Cook
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.32.3]
b. 4 Mar 1897 d. 8 Dec 1979 [
=>
]
12
Mary Unita Cook
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.32.4]
b. 23 Jun 1900 d. 11 Mar 1995 [
=>
]
12
Eliza Louisa Cook
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.32.5]
b. 3 Feb 1905 d. 5 Jun 1997 [
=>
]
+
Parley Afton Waters
b. 14 May 1872 d. 10 Sep 1938
11
George Hutchins Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.33]
b. 28 Jun 1869 d. 21 Feb 1940
Mary Jane Smith
b. 16 Dec 1866 d. 20 Mar 1926
12
Delbert Smith Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.33.1]
b. 4 Feb 1897 d. 8 May 1965 [
=>
]
12
Lila Jane Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.33.2]
b. 22 Sep 1900 d. 13 Dec 1951 [
=>
]
12
George Albert Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.33.3]
b. 2 Mar 1902 d. 24 Jul 1972
12
Alta Mary Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.33.4]
b. 12 Sep 1905 d. 12 Apr 1992
12
Etta A Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.33.5]
b. 1910
+
Vera Louisa Stallings
b. 12 Sep 1892 d. 6 Mar 1940
+
Pruscilla Beasley Gailey
b. Abt 1873
11
John Quinney Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.34]
b. 7 Jul 1863 d. 25 Oct 1920
Sarah Amanda Conrad
b. 30 Nov 1875 d. 13 May 1938
12
Mary Amanda Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.34.1]
b. 13 Oct 1893 d. Aug 1896
12
Tessie Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.34.2]
b. 11 Mar 1895 d. 21 Feb 1992 [
=>
]
12
Tabitha Bertha Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.34.3]
b. 30 Oct 1896 d. 6 Jul 1989 [
=>
]
12
Minnie Maude Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.34.4]
b. 6 Jun 1898 d. 21 Apr 1987 [
=>
]
12
Melvina Melvia Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.34.5]
b. 13 Apr 1900 d. 22 Aug 1959 [
=>
]
12
Bessie Belle Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.34.6]
b. 24 Sep 1901 d. 24 Mar 1981 [
=>
]
12
Kate Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.34.7]
b. 28 Apr 1903 d. 22 Feb 1990
12
Violet Valentine Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.34.8]
b. 14 Feb 1905 d. 10 Dec 1979 [
=>
]
12
Sylvia Mabel Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.34.9]
b. 3 Jun 1907 d. 17 Mar 1990 [
=>
]
12
George Edison Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.34.10]
b. 24 Jun 1909 d. 18 Feb 2007 [
=>
]
12
Jennie Lawrence Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.34.11]
b. 2 Mar 1911 d. 23 Sep 2004
12
Sarah Juanita Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.34.12]
b. 10 Dec 1912 d. 19 Apr 2001 [
=>
]
12
Laura May Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.34.13]
b. 2 Jan 1915 d. 12 Apr 2012
12
Daisy Odessa Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.8.34.14]
b. 7 Sep 1916 d. 25 Jan 2008 [
=>
]
10
Elvira Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.9]
b. 10 Mar 1807 d. 14 Nov 1881
James Miller
b. 22 Jun 1806 d. 27 Dec 1874
11
Laura Jane Miller
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.9.1]
b. 1832 d. 7 Feb 1892
+
Ebenezer Tucker
b. 24 Feb 1826 d. 19 Apr 1905
11
Mary Miller
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.9.2]
b. Oct 1833 d. 19 Aug 1881
John Keep Leonard
b. 29 May 1829 d. 1 Mar 1875
12
John F Leonard
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.9.2.1]
b. 1856
12
William Bradford Leonard
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.9.2.2]
b. 11 May 1858 d. 24 May 1934 [
=>
]
11
James Franklin Miller
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.9.3]
b. 1839 d. 20 Mar 1861
11
Franklin Miller
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.9.4]
b. 9 Oct 1841 d. 9 Mar 1846
11
William Aldrich Miller
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.9.5]
b. 9 Dec 1842 d. 23 Sep 1874
11
Samuel Edward Miller
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.9.6]
b. 10 Sep 1845 d. 18 Aug 1846
10
Maria Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.10]
b. 27 May 1809 d. 27 Dec 1816
10
Emeline Safford Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.11]
b. 20 Mar 1814 d. 22 Feb 1868
Oliver Dennett Kimball
b. 20 May 1820 d. 7 Nov 1867
11
Emma Jane Kimball
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.11.1]
b. 27 Aug 1845 d. 24 May 1888
Samuel Arius Darlington Sheppard
b. 16 Jul 1842 d. 28 Nov 1915
12
Clara Emma Sheppard
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.11.1.1]
b. 5 Jun 1870 d. 8 Feb 1942 [
=>
]
12
Robert Kimball Sheppard
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.11.1.2]
b. 6 Nov 1871 d. 22 Jan 1920 [
=>
]
12
Harwood Allen Sheppard
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.11.1.3]
b. 19 Feb 1881 d. 12 Jul 1954 [
=>
]
11
Oliver Dennett Kimball
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.11.2]
b. 6 Jun 1847 d. 29 Mar 1912
Mary Elizabeth Jones
b. Jul 1851
12
Mary Elizabeth Kimball
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.11.2.1]
b. 2 Oct 1871 [
=>
]
12
Florence Sheppard Kimball
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.11.2.2]
b. 15 Jun 1882 d. 9 Mar 1914 [
=>
]
11
Edward Richard Kimball
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.11.3]
b. 6 Sep 1849 d. 1 Aug 1916
Emma Doane Turner
b. 31 Oct 1850
12
Edward Richard Kimball, Jr
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.11.3.1]
b. 28 Nov 1871 [
=>
]
12
Lilian Emma Kimball
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.11.3.2]
b. 3 Apr 1876
12
Grace Kimball
[1.1.4.1.3.2.3.2.8.11.3.3]
b. 12 Jul 1877 d. 8 Apr 1887
9
Dimmis Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.2.9]
b. 5 Jul 1768 d. 1841
+
Blakely Safford
b. Abt 1759 d. Abt 1839
8
Joseph Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.3]
b. 1725 d. 1805
8
Daniel Whipple
[1.1.4.1.3.2.3.4]
b. Abt 1727
+
Zipporah Bolles
b. 11 Oct 1711 d. 1779
7
Daniel Whipple
[1.1.4.1.3.2.4]
b. 11 Oct 1698 d. 16 Apr 1789
Hannah Hough
b. 28 Dec 1718 d. 3 Oct 1768
8
Elizabeth Whipple
[1.1.4.1.3.2.4.1]
b. 15 Feb 1746
8
Anna Whipple
[1.1.4.1.3.2.4.2]
b. 15 Feb 1746 d. 26 Sep 1830
William Rogers
b. 5 Aug 1746 d. 2 Apr 1835
9
William Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.1]
b. 5 Jun 1770 d. 22 May 1851
Mary Hoyt
b. 25 Jul 1776 d. 21 Mar 1844
10
William Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.1.1]
b. 15 Jun 1795 d. 29 Aug 1796
10
James Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.1.2]
b. 14 Jun 1797 d. 1800
10
Eliza Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.1.3]
b. 12 Nov 1799 d. 13 Jun 1843
10
James Hervey Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.1.4]
b. 1801 d. 1842
+
Susan Beebe
10
William Eastman Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.1.5]
b. 12 Feb 1805 d. 11 Sep 1862
Eliza Teal
b. 18 Aug 1811 d. 14 Aug 1848
11
Mary E Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.1.5.1]
b. 1837
11
John Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.1.5.2]
b. 1839
11
Howard M Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.1.5.3]
b. 22 Apr 1840 d. 21 Jul 1862
11
Martha I Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.1.5.4]
b. 1841
11
Henrietta Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.1.5.5]
b. 31 Aug 1842
11
William Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.1.5.6]
b. 1844
11
Mary Jane Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.1.5.7]
b. 22 Sep 1844 d. 11 Jul 1845
11
Jason W Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.1.5.8]
b. 31 Jul 1846 d. 13 Sep 1847
+
Maria Webster
b. 31 Oct 1812
10
Benjamin Franklin Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.1.6]
b. 7 Feb 1807 d. 18 May 1841
Julia Jenkins
b. 3 Jun 1810
11
Julia Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.1.6.1]
b. 20 Sep 1834
11
Sarah Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.1.6.2]
b. 2 Apr 1836
11
Franklin Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.1.6.3]
b. 8 Apr 1838
11
Virginia Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.1.6.4]
b. 21 Sep 1840 d. 1842
10
Jason Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.1.7]
b. 11 Apr 1809 d. 18 Aug 1860
Elizabeth Hannah
b. Abt 1819
11
Jason Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.1.7.1]
b. Nov 1847
11
Sarah Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.1.7.2]
b. Sep 1848
11
Mary Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.1.7.3]
b. Nov 1854
11
Franklin Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.1.7.4]
b. Aug 1855
11
Thomas Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.1.7.5]
b. Dec 1856
9
Ann Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.2]
b. 5 Feb 1773 d. 12 Jul 1789
9
Mary Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.3]
b. 1 Sep 1774 d. 22 Mar 1779
9
Elisabeth Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.4]
b. 16 Apr 1776 d. 5 Jan 1779
9
Ichabod Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.5]
b. 24 Apr 1777 d. 18 Apr 1778
9
Lucy Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.6]
b. 7 Jul 1778 d. 9 Apr 1779
9
Hannah Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.7]
b. 7 Jul 1778 d. 24 Sep 1778
9
Daniel Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.8]
b. 17 Feb 1780 d. 12 Jul 1839
Rebecca Conklin
b. 24 Feb 1792 d. 4 Dec 1847
10
Mary Ann Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.8.1]
b. 28 Apr 1825 d. 5 Oct 1897
+
Buel Titus
b. 24 Feb 1824 d. 15 Dec 1889
10
Helen Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.8.2]
b. 25 Apr 1828 d. 7 Aug 1874
Platt Titus
b. 18 Sep 1828 d. 26 Nov 1878
11
Irene White Titus
[1.1.4.1.3.2.4.2.8.2.1]
b. 17 Apr 1851 d. 8 May 1854
11
Isadora Titus
[1.1.4.1.3.2.4.2.8.2.2]
b. 26 Mar 1853 d. 28 Mar 1885
11
Henry B Titus
[1.1.4.1.3.2.4.2.8.2.3]
b. 5 Aug 1855 d. 15 Mar 1885
11
Herbert R Titus
[1.1.4.1.3.2.4.2.8.2.4]
b. 9 Feb 1858 d. 21 Nov 1913
11
Margaret Conklin Titus
[1.1.4.1.3.2.4.2.8.2.5]
b. 6 Mar 1860 d. 1943
Myron A Mahan
b. 1859 bur. 12 May 1903
12
Herbert T Mahan
[1.1.4.1.3.2.4.2.8.2.5.1]
b. 17 Jan 1887 d. Abt 7 Oct 1970
11
Harriet Kissam Titus
[1.1.4.1.3.2.4.2.8.2.6]
b. 1 Apr 1863 d. 9 Feb 1940
11
Rudolph Lincoln Titus
[1.1.4.1.3.2.4.2.8.2.7]
b. 16 Apr 1865 d. 13 Dec 1937
+
Edith Estelle Moffatt
b. 7 May 1863 d. 23 Dec 1892
11
Mary Rebecca Titus
[1.1.4.1.3.2.4.2.8.2.8]
b. 10 Jul 1867 d. 24 Dec 1872
11
Helen Rogers Titus
[1.1.4.1.3.2.4.2.8.2.9]
b. 16 Feb 1869 d. 22 Jan 1956
9
Mary Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.9]
b. 31 Dec 1781 d. 30 Nov 1782
9
David Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.10]
b. 11 Feb 1783 d. 1849
Amy Ann Allan
b. 1786
10
Leander Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.10.1]
b. 12 Nov 1808 d. 30 Oct 1849
Mary Campbell
b. Abt 1812
11
Mary Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.10.1.1]
b. 12 Dec 1841
11
George L Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.10.1.2]
b. 26 Aug 1843
11
Leander A Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.10.1.3]
b. 7 Apr 1845
11
William F Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.10.1.4]
b. 12 Oct 1846
10
Jeremiah Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.10.2]
b. 19 Jan 1811
10
Emma Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.10.3]
b. 17 May 1814 d. 30 Jun 1898
William Halsey Jessup
b. 1812 d. 1855
11
Amy Ann Jessup
[1.1.4.1.3.2.4.2.10.3.1]
b. 20 Jul 1841 d. 22 Jul 1900
11
Charles P Jessup
[1.1.4.1.3.2.4.2.10.3.2]
b. 23 Apr 1850
11
George H Jessup
[1.1.4.1.3.2.4.2.10.3.3]
b. 23 Mar 1852
Adda J Jones
12
Emma Jessup
[1.1.4.1.3.2.4.2.10.3.3.1]
b. 1889 d. 1969 [
=>
]
12
Mary Alice Jessup
[1.1.4.1.3.2.4.2.10.3.3.2]
b. 1895
10
George Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.10.4]
b. 8 Jul 1819
10
Nathan Griswald Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.10.5]
b. 21 Oct 1821 d. 2 Feb 1849
Amy E Gay
b. 20 Feb 1824
11
Newton Gay Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.10.5.1]
b. 1846 d. 4 Jul 1911
+
Celine DelVecchio
b. 1854 d. 1900
Fannie L Locke
b. Aug 1868 d. 26 Apr 1948
12
Claire L Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.10.5.1.1]
b. 1886
12
Newton Gregory Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.10.5.1.2]
b. 27 Mar 1889 d. 26 Oct 1956
12
Ophelia W Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.10.5.1.3]
b. 1892
12
Nathan Louis Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.10.5.1.4]
b. 27 Jul 1894 d. May 1974 [
=>
]
12
Annie Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.10.5.1.5]
b. 1900
12
Winchester W Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.10.5.1.6]
b. 1902 d. 7 Jun 1960
12
Florence C Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.10.5.1.7]
b. 1904
11
Florence Emma Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.10.5.2]
b. 1848 d. 16 Dec 1901
+
William J Durning
10
Anna Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.10.6]
b. 28 Dec 1821 d. 28 May 1826
10
Elizabeth Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.10.7]
b. 17 Apr 1824 d. 24 May 1847
10
David Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.10.8]
b. 5 Sep 1826 d. 22 Dec 1848
9
Ichabod Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.11]
b. 10 Dec 1784 d. 4 Nov 1860
Eliza Cooper
b. 1785 d. 14 Aug 1862
10
Ann Eliza Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.11.1]
b. 9 Sep 1812 d. 5 Apr 1891
John Curtis Dormandy
b. 26 Dec 1806 d. 4 Jun 1879
11
Margaret Dormandy
[1.1.4.1.3.2.4.2.11.1.1]
b. 29 Sep 1836 d. 28 Jun 1853
11
Elizabeth Cooper Dormandy
[1.1.4.1.3.2.4.2.11.1.2]
b. 15 Oct 1838 d. 7 Nov 1888
+
Charles Jenkins
b. 1825 d. 1890
11
Ann Whipple Dormandy
[1.1.4.1.3.2.4.2.11.1.3]
b. 14 Jan 1840 d. 18 Oct 1884
11
Julia Dormandy
[1.1.4.1.3.2.4.2.11.1.4]
b. 23 Oct 1842 d. 10 Oct 1892
11
Robert Dormandy
[1.1.4.1.3.2.4.2.11.1.5]
b. 10 Sep 1847
10
Ferdinand Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.11.2]
b. Abt 1815 d. 17 Jan 1876
Angeline Stone
d. 28 Mar 1845
11
George Edgar Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.11.2.1]
b. 24 Feb 1840 d. 12 Sep 1840
11
Frederick Cooper Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.11.2.2]
b. 8 Sep 1842 d. 21 Jun 1872
11
George Newel Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.11.2.3]
b. 22 Mar 1845 d. 12 Aug 1848
Jeannette Sylvia Loomis
b. Jun 1822 d. 17 Jan 1876
11
Henry William Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.11.2.4]
b. 7 Apr 1849 d. 24 Sep 1851
11
Angelene Eliza Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.11.2.5]
b. 23 Nov 1851
11
Margaret Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.11.2.6]
b. 6 Dec 1853 d. 13 Jan 1870
11
Charles Loomis Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.11.2.7]
b. 1859
+
Fannie Alder Webb
b. 8 Feb 1858 d. 6 Dec 1942
10
Edgar Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.11.3]
b. 8 Oct 1819
10
Robert Cooper Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.11.4]
b. Abt 1822 d. 20 Jun 1888
Anna Rosalie Pratt
b. Abt 1826
11
Florence Anna Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.11.4.1]
b. Abt 1852
11
Herbert Cooper Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.11.4.2]
b. Oct 1855 d. 29 Apr 1912
Adelaide Palmer Merriam
b. 14 Feb 1860 d. 17 Aug 1912
12
Robert Merriam Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.11.4.2.1]
b. 3 Apr 1884 d. 13 May 1941
Louisa
b. 1830
11
Louisa Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.11.4.3]
b. 1864 d. 25 Feb 1865
11
Bessie Cooper Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.11.4.4]
b. 3 Sep 1866
9
Mehitable Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.12]
b. 4 Oct 1788
Charles Gilbert Irish
b. 20 Jan 1791 d. 12 Jul 1869
10
Benjamin Gardner Irish
[1.1.4.1.3.2.4.2.12.1]
b. 31 Mar 1814 d. 15 Mar 1875
+
Hannah S Daws
b. Abt 1818 d. 2 Aug 1835
Susan Dickerson
b. 1835
11
Harriet A Irish
[1.1.4.1.3.2.4.2.12.1.1]
b. 1859
Silas Wesley Berry
b. Oct 1859
12
Edith Carrie Berry
[1.1.4.1.3.2.4.2.12.1.1.1]
b. Apr 1885 d. 1923 [
=>
]
12
Royal B Berry
[1.1.4.1.3.2.4.2.12.1.1.2]
b. Nov 1887
11
Charles Irish
[1.1.4.1.3.2.4.2.12.1.2]
b. 1864 d. Bef 1870
11
Benjamin Irish
[1.1.4.1.3.2.4.2.12.1.3]
b. Aug 1869
10
Harriet Ann Irish
[1.1.4.1.3.2.4.2.12.2]
b. 14 Dec 1815 d. 10 Dec 1817
10
Charles Gilbert Irish
[1.1.4.1.3.2.4.2.12.3]
b. 14 May 1817 d. 22 Jan 1901
Ann Patterson
b. Abt 1820 d. Bef 1899
11
John Patterson Irish
[1.1.4.1.3.2.4.2.12.3.1]
b. 26 Jun 1846 d. 15 May 1922
11
Agnes Rebecca Irish
[1.1.4.1.3.2.4.2.12.3.2]
b. 23 Nov 1847 d. 29 Mar 1889
Stephen Fish Sherman
b. 1845
12
Stephen F Sherman
[1.1.4.1.3.2.4.2.12.3.2.1]
b. Abt 1871
12
Agnes Rogers Sherman
[1.1.4.1.3.2.4.2.12.3.2.2]
b. 1872 [
=>
]
12
Stephen Fish Sherman
[1.1.4.1.3.2.4.2.12.3.2.3]
b. 16 Jul 1874 d. 1938
12
Grace Fish Sherman
[1.1.4.1.3.2.4.2.12.3.2.4]
b. Abt 1875 d. 9 Aug 1964
11
Anna R Rogers Irish
[1.1.4.1.3.2.4.2.12.3.3]
b. Abt 1849
11
Jennie R Irish
[1.1.4.1.3.2.4.2.12.3.4]
b. Abt 1851
11
Harriet L Irish
[1.1.4.1.3.2.4.2.12.3.5]
b. Abt 1851
11
Jennie P Irish
[1.1.4.1.3.2.4.2.12.3.6]
b. Sep 1860
10
Caroline Matilda Irish
[1.1.4.1.3.2.4.2.12.4]
b. 8 Feb 1819
James McCredie
b. Abt 1815
11
Caroline Eaton McCredie
[1.1.4.1.3.2.4.2.12.4.1]
b. 24 Feb 1842
11
Rebecca Matilda McCredie
[1.1.4.1.3.2.4.2.12.4.2]
b. 12 Apr 1844 d. 14 Apr 1844
11
James McCredie
[1.1.4.1.3.2.4.2.12.4.3]
b. Abt 1846
11
William Norman McCredie
[1.1.4.1.3.2.4.2.12.4.4]
b. Abt 1847
10
William Norman Irish
[1.1.4.1.3.2.4.2.12.5]
b. 19 Mar 1821 d. 2 Dec 1896
Emma Juliet Lewin
b. 13 Dec 1827 d. 1910
11
William Norman Irish
[1.1.4.1.3.2.4.2.12.5.1]
b. 6 Aug 1850 d. 7 Nov 1852
11
Charles Gilbert Irish
[1.1.4.1.3.2.4.2.12.5.2]
b. 15 Feb 1852
Louisa Collins Standin
b. 1849
12
Elizabeth Standin Irish
[1.1.4.1.3.2.4.2.12.5.2.1]
b. 9 Oct 1880
12
William Norman Irish
[1.1.4.1.3.2.4.2.12.5.2.2]
b. 5 Nov 1882 d. 30 Oct 1946 [
=>
]
12
James McCredie Irish
[1.1.4.1.3.2.4.2.12.5.2.3]
b. 25 Jul 1885
12
Mary Standin Irish
[1.1.4.1.3.2.4.2.12.5.2.4]
b. 1887 d. 1965
11
Edward Ingersoll Irish
[1.1.4.1.3.2.4.2.12.5.3]
b. 11 Jan 1854 d. 15 Jul 1876
11
Lydia Irish
[1.1.4.1.3.2.4.2.12.5.4]
b. Abt 1855
11
Mary Green Irish
[1.1.4.1.3.2.4.2.12.5.5]
b. 29 Dec 1856 d. 25 Nov 1871
11
Benjamin Walter Irish
[1.1.4.1.3.2.4.2.12.5.6]
b. 10 Mar 1858 d. 24 Mar 1874
11
George Merriweather Irish
[1.1.4.1.3.2.4.2.12.5.7]
b. 3 Sep 1861 d. 28 Jan 1954
Helen E Stevenson
b. Jul 1862 d. Aft 1910
12
Charles Gilbert Irish
[1.1.4.1.3.2.4.2.12.5.7.1]
b. 8 Dec 1889 d. Nov 1969 [
=>
]
11
Sally Irish
[1.1.4.1.3.2.4.2.12.5.8]
b. Abt 1862
11
Alice Emma Irish
[1.1.4.1.3.2.4.2.12.5.9]
b. 11 Dec 1870 d. 16 Aug 1874
10
Sarah Irish
[1.1.4.1.3.2.4.2.12.6]
b. 30 Mar 1823
+
John E Russell
10
Lydia Gardner Irish
[1.1.4.1.3.2.4.2.12.7]
b. 17 Aug 1827 d. 29 Jul 1849
Joshua L Parish
b. Abt 1827
11
Mary Mehitable Parish
[1.1.4.1.3.2.4.2.12.7.1]
b. 19 Nov 1848
10
Mary Budd Irish
[1.1.4.1.3.2.4.2.12.8]
b. 17 Nov 1829
10
Maria Louise Irish
[1.1.4.1.3.2.4.2.12.9]
b. 15 Nov 1843
9
Jememiah Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.13]
b. 4 Jul 1789
Sarah Vosburg
b. Abt 1793
10
Mary Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.13.1]
b. Abt 1816
10
Sarah Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.13.2]
b. Abt 1818
Urbane Havens
b. 9 Apr 1819 d. 26 Aug 1868
11
George Haven
[1.1.4.1.3.2.4.2.13.2.1]
b. 27 Mar 1844
+
Ella A Beckwith
b. 18 Dec 1847 d. 4 Oct 1877
11
Mary Elizabeth Haven
[1.1.4.1.3.2.4.2.13.2.2]
b. 26 Jul 1845
Charles Alva Thrall
b. 1 Apr 1843
12
Charles Urbane Thrall
[1.1.4.1.3.2.4.2.13.2.2.1]
b. 2 May 1868 d. 20 Dec 1919 [
=>
]
12
Lena Juliette Thrall
[1.1.4.1.3.2.4.2.13.2.2.2]
b. 13 Aug 1869
11
Catherine Haven
[1.1.4.1.3.2.4.2.13.2.3]
b. 31 Mar 1847 d. 19 Oct 1887
James L Eggleston
b. 24 Jul 1843 d. 20 Sep 1915
12
Mary Eggleston
[1.1.4.1.3.2.4.2.13.2.3.1]
b. 3 Oct 1866 d. 8 Feb 1960 [
=>
]
12
Martha S "Mattie" Eggleston
[1.1.4.1.3.2.4.2.13.2.3.2]
b. May 1868 d. 23 Mar 1911
12
James Thomas Eggleston
[1.1.4.1.3.2.4.2.13.2.3.3]
b. 25 Oct 1874 d. 26 Sep 1952 [
=>
]
11
Urban Haven
[1.1.4.1.3.2.4.2.13.2.4]
b. 9 Jun 1849
11
Jonathan C Haven
[1.1.4.1.3.2.4.2.13.2.5]
b. 11 May 1853
11
Sarah J Haven
[1.1.4.1.3.2.4.2.13.2.6]
b. 9 Jul 1855 d. 1938
10
Charles Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.13.3]
b. Abt 1820
10
Jeremiah Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.13.4]
b. Abt 1822
10
Edgar Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.13.5]
b. Abt 1824
10
Amelia Rogers
[1.1.4.1.3.2.4.2.13.6]
b. Abt 1826
8
Lucretia Whipple
[1.1.4.1.3.2.4.3]
b. 15 Jan 1748
8
Jeremiah Whipple
[1.1.4.1.3.2.4.4]
b. 1 Mar 1751 d. 1830
8
Phebe Whipple
[1.1.4.1.3.2.4.5]
b. 11 Mar 1753
Joseph Fuller
b. 19 Feb 1744
9
Lucy Fuller
[1.1.4.1.3.2.4.5.1]
b. 29 Oct 1769 d. 1 Aug 1823
John Tuthill
b. 30 Jun 1766 d. 25 Sep 1836
10
John Tuthill
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.1]
b. 7 Aug 1792
10
Tyrus Tuthill
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.2]
b. 30 Mar 1794 d. 2 Dec 1891
Elizabeth Brown
b. 29 Dec 1792 d. 15 Mar 1884
11
Mandeville Tuthill
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.2.1]
b. 28 Sep 1818 d. 16 Oct 1847
11
David Tuthill
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.2.2]
b. 11 Oct 1819 d. 1 Apr 1897
Annis H Francis
b. 26 May 1825 d. 29 Aug 1895
12
John Tuthill
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.2.2.1]
b. 1845 d. 5 Mar 1853 [
=>
]
12
Mary E Tuthill
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.2.2.2]
b. 1 Jan 1848 d. 12 Aug 1868
12
Mandeville E Tuthill
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.2.2.3]
b. 20 Feb 1851 d. 23 Dec 1931
12
Spencer F Tuthill
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.2.2.4]
b. 20 Feb 1853 d. 17 Mar 1909 [
=>
]
12
Harriet Melvina Tuthill
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.2.2.5]
b. 1 Jan 1859 d. 1939 [
=>
]
12
Martha E Tuthill
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.2.2.6]
b. 29 Aug 1866 d. 20 Jan 1870
11
Phebe Tuthill
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.2.3]
b. 26 Aug 1821 d. 11 Feb 1842
11
Harriet M Tuthill
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.2.4]
b. 12 May 1824 d. 24 May 1846
11
Lucy Tuthill
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.2.5]
b. 12 Oct 1826 d. 27 Apr 1870
Edwin L Seely
b. 9 Mar 1828 d. 4 Oct 1891
12
Elizabeth Seely
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.2.5.1]
b. Apr 1861
12
Anna G Seely
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.2.5.2]
b. 8 Apr 1863
11
Cynthia Tuthill
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.2.6]
b. 6 Jul 1828 d. 22 Aug 1850
11
Charles Tuthill
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.2.7]
b. Abt 1829 d. 27 Oct 1864
Julia Esther Terry
b. 30 Jun 1830 d. 18 Dec 1905
12
Sadie Tuthill
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.2.7.1]
b. 1862
11
John Tuthill
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.2.8]
b. 2 Dec 1832 d. 5 Feb 1834
11
Martha Jane Tuthill
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.2.9]
b. 24 Nov 1834 d. 19 Jul 1835
10
Martha Tuthill
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.3]
b. 5 Apr 1800 d. 15 Aug 1879
Claudius Chamberlain
b. 3 Oct 1797 d. 8 Sep 1865
11
Eliza Ann Chamberlain
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.3.1]
b. 1 Sep 1821
11
Addison Chamberlain
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.3.2]
b. 7 Dec 1822
11
Adison Chamberlain
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.3.3]
b. 1823
11
Cynthia Chamberlain
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.3.4]
b. 7 Jun 1825 d. 4 Jan 1850
11
Lucy Chamberlain
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.3.5]
b. 1827
11
Myron Chamberlain
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.3.6]
b. 13 May 1829 d. 1868
Sally Mariah Hunt
b. 1831 d. 1888
12
Leah Ann Chamberlain
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.3.6.1]
b. 1853
12
Ida L Chamberlain
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.3.6.2]
b. 1856 d. 1895 [
=>
]
12
Ellen Chamberlain
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.3.6.3]
b. 1860
12
Adelbert M Chamberlain
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.3.6.4]
b. 1863 d. 30 May 1930 [
=>
]
12
Jane Chamberlain
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.3.6.5]
b. 1866
12
George M Chamberlain
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.3.6.6]
b. 1868 [
=>
]
11
Miren Chamberlain
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.3.7]
b. 1830
11
Mary Chamberlain
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.3.8]
b. 1831
11
Lille M Chamberlin
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.3.9]
b. 1832
11
John Chamberlain
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.3.10]
b. 30 Aug 1833
11
Henry Chamberlain
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.3.11]
b. 1837
11
Rosanne Chamberlain
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.3.12]
b. 1840
11
Eagar Chamberlain
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.3.13]
b. 17 Jul 1841
11
Edgar Chamberlain
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.3.14]
b. 1842
11
Milton Chamberlain
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.3.15]
b. 11 Nov 1843
10
Sanford Tuthill
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.4]
b. 11 Sep 1802 d. 22 Mar 1883
Harriet M Greene
b. 27 Apr 1800 d. 1 Mar 1843
11
Albert Gallatin Tuthill
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.4.1]
b. 7 Dec 1825 d. 20 Jul 1915
Mary E Platner
b. 29 Nov 1830 d. 31 Oct 1910
12
Minnie Tuthill
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.4.1.1]
b. 7 Feb 1859 d. 4 Aug 1936 [
=>
]
11
Julia E Tuthill
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.4.2]
b. 20 Nov 1827
+
Wormwood
b. 1825
11
Olive Tuthill
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.4.3]
b. 13 Jul 1830 d. 20 Dec 1907
Joseph D Bunn
b. 1 Feb 1830 d. 1911
12
Arthur S Bunn
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.4.3.1]
b. 1857 d. 1858
12
Son Bunn
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.4.3.2]
b. 1858
12
Harriet F Bunn
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.4.3.3]
b. 1859 d. 1860
12
Son Bunn
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.4.3.4]
b. 1860
12
Charles T Bunn
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.4.3.5]
b. 1861 d. 1882
11
Son Tuthill
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.4.4]
b. 1832
11
Mary Tuthill
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.4.5]
b. 13 Oct 1833
11
John Tuthill
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.4.6]
b. 14 Jul 1835 d. 18 Nov 1920
Mary A Livingston
b. 10 Dec 1855 d. 28 Jul 1926
12
John Tuthill
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.4.6.1]
b. 10 Feb 1878
12
Julia Emmett Tuthill
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.4.6.2]
b. 7 Dec 1879 d. 17 Apr 1965
12
Catherine Olive Tuthill
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.4.6.3]
b. 30 Jul 1891
12
Harry A Tuthill
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.4.6.4]
b. 31 Jan 1895
11
Tyrues Truman Tuthill
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.4.7]
b. 13 Oct 1837 d. 4 Jul 1921
Harriet S Robinson
b. 1839 d. 26 Apr 1903
12
Theodore Robinson Tuthill
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.4.7.1]
b. 19 Jul 1868 d. 14 Dec 1922
11
Son Tuthill
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.4.8]
b. 1839
11
Theodore Ely Tuthill
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.4.9]
b. 6 Dec 1841 d. 13 Mar 1923
Mary Frances Gee
b. 11 Mar 1840 d. 18 Mar 1912
12
Bell E Tuthill
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.4.9.1]
b. 3 Dec 1871
+
Emmorette Hotchkiss
b. 5 May 1807 d. 1877
10
Cynthia Tuthill
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.5]
b. 30 Sep 1804 d. 2 Nov 1859
Charles Pettibone
b. 30 Aug 1802 d. 5 Oct 1856
11
Lucy Belinda Pettibone
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.5.1]
b. 3 Sep 1827
11
Lodicy Amelia Pettibone
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.5.2]
b. 5 Oct 1830 d. 7 Oct 1857
11
Son Pettibone
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.5.3]
b. Abt 1832
11
Son Pettibone
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.5.4]
b. Abt 1833
11
Daughter Pettibone
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.5.5]
b. Abt 1833
11
Son Pettibone
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.5.6]
b. Abt 1834
11
Clarissa Pettibone
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.5.7]
b. 13 Apr 1834
11
Son Pettibone
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.5.8]
b. Abt 1837
11
Daughter Pettibone
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.5.9]
b. Abt 1837
11
Daniel Pettibone
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.5.10]
b. 22 Sep 1837 d. 30 Nov 1841
11
William Henry Pettibone
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.5.11]
b. 30 Mar 1840 d. 1936
Mary M Nourse
b. 1841 d. 16 Jun 1935
12
Lillian Pettibone
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.5.11.1]
b. 15 May 1861 d. 14 Mar 1948 [
=>
]
11
Mary Adelia Pettibone
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.5.12]
b. 1 Jul 1843 d. 22 Sep 1873
+
Henry Maxwell Frame
b. 6 Dec 1842 d. 5 Dec 1919
11
Harriet Melvina Pettibone
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.5.13]
b. 28 Feb 1846 d. 30 Sep 1900
Nathaniel Hyde LeClear
b. 14 Jul 1841 d. 3 Jun 1915
12
Elizabeth Martha LeClear
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.5.13.1]
b. 10 Feb 1876 d. 16 Jan 1903
12
Florence Mae LeClear
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.5.13.2]
b. 2 Nov 1885 d. 15 Mar 1963
11
Cynthia Elizabeth Pettibone
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.5.14]
b. 17 Sep 1848
10
Harriet Melvina Tuthill
[1.1.4.1.3.2.4.5.1.6]
b. 18 Feb 1814 d. 8 Jun 1859
9
Joseph Fuller, Jr
[1.1.4.1.3.2.4.5.2]
b. Abt 1771 d. Aft 1835
9
William Fuller
[1.1.4.1.3.2.4.5.3]
b. 1775 d. Aft 1820
9
Johnathan Fuller
[1.1.4.1.3.2.4.5.4]
b. Bef 1784
9
Mary Fuller
[1.1.4.1.3.2.4.5.5]
b. 5 Jul 1784 d. 1865
Levi Lawrence
b. 15 Jun 1784 d. 1832
10
Eliza Hunt Lawrence
[1.1.4.1.3.2.4.5.5.1]
b. 1808 d. 1866
+
James Jenning Thompson
b. 1803 d. 1840
10
Mary Ann Lawrence
[1.1.4.1.3.2.4.5.5.2]
b. 17 Aug 1809 d. 1847
Augustus Heaslip Evans
b. 1 Nov 1792 d. 1863
11
Theresa Evans
[1.1.4.1.3.2.4.5.5.2.1]
b. 16 Dec 1837 d. 13 Oct 1916
James Lewis Chastain Buskett
b. 19 Dec 1826 d. 28 Jan 1912
12
William Buskett
[1.1.4.1.3.2.4.5.5.2.1.1]
b. 1858
12
James Lawrence Buskett
[1.1.4.1.3.2.4.5.5.2.1.2]
b. 19 Aug 1866 d. 25 May 1905
12
Louis Wade Buskett
[1.1.4.1.3.2.4.5.5.2.1.3]
b. 22 Aug 1868 d. 27 Jul 1915 [
=>
]
12
Nancy Haislip Buskett
[1.1.4.1.3.2.4.5.5.2.1.4]
b. 28 Mar 1870 d. 28 Mar 1938
12
Mary Page Buskett
[1.1.4.1.3.2.4.5.5.2.1.5]
b. 10 Jul 1872 d. 24 Mar 1935
12
Evans Walker Buskett
[1.1.4.1.3.2.4.5.5.2.1.6]
b. 20 Sep 1874 d. 13 Jan 1952 [
=>
]
12
Son Buskett
[1.1.4.1.3.2.4.5.5.2.1.7]
b. 8 Jan 1877
11
Clara Evans
[1.1.4.1.3.2.4.5.5.2.2]
b. 1840
11
Byrd Evans
[1.1.4.1.3.2.4.5.5.2.3]
b. 1842 d. 3 Apr 1881
11
Walker Evans
[1.1.4.1.3.2.4.5.5.2.4]
b. 29 May 1844 bur. 1928
Amanda Brooks
b. 18 Feb 1846 d. 28 Feb 1928
12
Mabel Lawrence Evans
[1.1.4.1.3.2.4.5.5.2.4.1]
b. 10 Aug 1869 d. 9 Apr 1947
12
Walker Evans
[1.1.4.1.3.2.4.5.5.2.4.2]
b. 29 Jan 1879 d. 1933 [
=>
]
12
Lydia Evans
[1.1.4.1.3.2.4.5.5.2.4.3]
b. Abt 1881
12
Byrd Evans
[1.1.4.1.3.2.4.5.5.2.4.4]
b. 1881 d. 3 Apr 1881
12
Clara Evans
[1.1.4.1.3.2.4.5.5.2.4.5]
b. Abt 1883
11
Lydia Evans
[1.1.4.1.3.2.4.5.5.2.5]
b. 1846 d. 1 Mar 1884
Edward P McCarty
b. 1847
12
Evans McCarty
[1.1.4.1.3.2.4.5.5.2.5.1]
b. 8 Sep 1872 d. Sep 1933
12
Ralph McCarty
[1.1.4.1.3.2.4.5.5.2.5.2]
b. 28 Jul 1875 d. 11 Nov 1951 [
=>
]
11
Sarah Evans
[1.1.4.1.3.2.4.5.5.2.6]
d. Oct 1866
9
Levi Fuller
[1.1.4.1.3.2.4.5.6]
b. Abt 1791 d. Aft 1870
Charlotte Barrows
b. 30 Dec 1786
10
William Fuller
[1.1.4.1.3.2.4.5.6.1]
b. Abt 1814
10
Clarissa Fuller
[1.1.4.1.3.2.4.5.6.2]
b. Abt 1815
10
Willard Fuller
[1.1.4.1.3.2.4.5.6.3]
+
Rebekah Bugbey
+
Mary Riblet
b. 1791
9
Sarah Fuller
[1.1.4.1.3.2.4.5.7]
b. 22 Feb 1792 d. 27 May 1829
Ruben Haley
b. 15 May 1786 d. 17 Aug 1820
10
Cynthia Ann Haley
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.1]
b. 24 Oct 1813 d. 9 Feb 1899
Loren Cook
b. 11 Feb 1814 d. 15 Mar 1895
11
Sarah Pauline Cook
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.1.1]
b. 30 Jan 1837 d. 1 Jun 1841
11
George J Cook
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.1.2]
b. 19 May 1839 d. 16 Jul 1839
11
Adeline Cook
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.1.3]
b. 18 Oct 1841 d. 22 May 1871
John Harper
b. 1841
12
Addie May Harper
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.1.3.1]
b. 21 Jan 1868 d. 14 Oct 1917 [
=>
]
12
Milo Harper
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.1.3.2]
b. 10 Oct 1870 d. 18 Jul 1904
11
Lucinda Cook
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.1.4]
b. 9 Jul 1845 d. 15 Feb 1894
11
Ruben Lorenze Cook
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.1.5]
b. 1 Mar 1848 d. 19 Jul 1919
11
Edmond E Cook
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.1.6]
b. 4 Feb 1851 d. 19 Nov 1929
11
Millard Cook
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.1.7]
b. 5 May 1854 d. 21 Nov 1854
11
Louise Adellia Cook
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.1.8]
d. 27 Dec 1865
10
Thomas Jefferson Haley
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.2]
b. 14 Oct 1817 d. 19 Jul 1898
10
Ruben Haley
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.3]
b. 1819 d. 5 Oct 1847
Dennison Stearns
b. 4 Jan 1792 d. 23 Jan 1875
10
Joseph Denison Stearns
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.4]
b. 26 Nov 1827 d. 23 Jan 1903
Sarah Elisabeth Bigler
b. 6 Feb 1834 d. 15 Jan 1865
11
Sarah Ann Stearns
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.4.1]
b. 9 Jan 1856 d. 30 Aug 1857
11
John M Stearns
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.4.2]
b. 19 Sep 1857 d. 5 Sep 1929
Anna Brown
b. 13 Dec 1858 d. 11 Sep 1935
12
Florence Stearns
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.4.2.1]
b. 20 Jun 1888 d. 12 Oct 1981
11
William D Stearns
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.4.3]
b. 12 Oct 1859 d. 11 Jun 1860
11
Eva Savilla Stearns
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.4.4]
b. 22 May 1861 d. 29 Feb 1912
John M Brown
b. 7 Dec 1860 d. 25 Sep 1939
12
Earl M Brown
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.4.4.1]
b. 27 Feb 1883 d. 4 Mar 1978 [
=>
]
12
Bell Brown
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.4.4.2]
b. 1884 d. 19 Feb 1892
12
Willis Abler Brown
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.4.4.3]
b. 29 Oct 1886 d. 16 Mar 1912
12
Anna Luella Brown
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.4.4.4]
b. 30 Jan 1889 d. 22 Jan 1984
12
Daughter Brown
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.4.4.5]
b. 19 Oct 1891 d. 1892
12
Son Brown
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.4.4.6]
b. 19 Oct 1891
12
Janie E Brown
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.4.4.7]
b. 18 Oct 1896 d. 15 Aug 1985
12
James E Brown
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.4.4.8]
b. 18 Oct 1896 d. 29 Nov 1896
11
Joseph Stearns
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.4.5]
b. 6 Jan 1865 d. 6 Jul 1936
Hattie Zeigler
b. 7 May 1866 d. 1 May 1946
12
Alma Almeda Stearns
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.4.5.1]
b. 15 Nov 1885 d. 5 Jun 1964 [
=>
]
12
Bessie May Stearns
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.4.5.2]
b. 23 Feb 1887 d. 4 Feb 1970
12
Sadie Vere Stearns
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.4.5.3]
b. 26 Dec 1889 d. 11 Jan 1979
12
Elmer Stearns
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.4.5.4]
b. 28 Jun 1891 d. 30 Sep 1981
12
Ethel Stearns
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.4.5.5]
b. 18 Nov 1893 d. 30 Jun 1974
12
Lester Ray Stearns
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.4.5.6]
b. 7 Mar 1897 d. 1965
12
Kenneth J Stearns
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.4.5.7]
b. 20 Jul 1899 d. Jan 1966
12
Julia Etta Stearns
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.4.5.8]
b. 5 Nov 1901 d. 21 Jan 1987
12
Orilla May Stearns
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.4.5.9]
b. 20 Mar 1904 d. 8 Sep 1990
12
Elsie Christina Stearns
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.4.5.10]
b. 30 Dec 1907 d. 16 Sep 1996
12
Dorothy Stearns
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.4.5.11]
b. 2 Apr 1910 d. 2 Nov 1974
Julia M Plato
b. 5 Aug 1848 d. 8 Nov 1905
11
Mary Elizabeth Stearns
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.4.6]
b. 15 Sep 1867 d. 12 Mar 1917
+
Richard Blake
11
Henry Stearns
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.4.7]
b. Aug 1870 d. 17 Nov 1890
11
Ida May Stearns
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.4.8]
b. 21 Oct 1874 d. 31 Jan 1933
+
Lou Olson
11
Clarissa Stearns
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.4.9]
b. 25 Feb 1877 d. 1970
Samuel Zeigler
b. 15 Oct 1871 d. 22 Dec 1948
12
Harold Morton Zeigler
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.4.9.1]
b. 1903 d. 1969 [
=>
]
12
Mildred V Zeigler
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.4.9.2]
b. 1905
12
Samuel E Zeigler
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.4.9.3]
b. 1906
12
Vance Arden Zeigler
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.4.9.4]
b. 1908 d. 28 Dec 1989
12
Herman G Zeigler
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.4.9.5]
b. 1908 d. 1977
11
Rueben Gaylord Stearns
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.4.10]
b. 21 Sep 1878 d. 7 May 1944
Bessie Louella Harwood
b. 8 Jul 1879 d. 18 Sep 1956
12
Harry Earl Stearns
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.4.10.1]
b. 23 Dec 1904 d. 8 Apr 1972
12
Ralph Harwood Stearns
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.4.10.2]
b. Sep 1906 d. 6 Jul 1983
12
Grace Alvera Stearn
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.4.10.3]
b. May 1908
12
Frederick Marion Stearns
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.4.10.4]
b. 3 Aug 1910 d. 5 Aug 1989
11
Edwin Plato Stearns
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.4.11]
b. 15 Aug 1880 d. Jul 1964
Alice Vinton
b. 7 Jul 1888 d. 20 Jun 1968
12
George Forest Stearns
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.4.11.1]
b. 24 May 1910 d. 5 Sep 1993
12
Malene Stearns
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.4.11.2]
b. 20 Dec 1912 d. 27 Jun 1988
12
Wilfred Vinton Stearns
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.4.11.3]
b. 1917 d. 7 Jan 2003
12
Wilma J Stearns
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.4.11.4]
b. 15 May 1919 d. 3 Oct 2010
11
Guyon L Stearns
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.4.12]
b. 22 Jan 1887 d. Jan 1973
May Elouise Lampman
b. 26 Jun 1886
12
Luellen Stearns
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.4.12.1]
b. 17 Aug 1914
12
Guyon Stearns
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.4.12.2]
b. 24 Aug 1917 d. 6 Feb 2007
12
Living
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.4.12.3]
10
Reuben Stearns
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.5]
b. 23 Nov 1829
10
George Stearns
[1.1.4.1.3.2.4.5.7.6]
b. 1850
8
Ebenezer Whipple
[1.1.4.1.3.2.4.6]
b. 4 Jun 1755 d. 2 Nov 1826
8
Priscilla Whipple
[1.1.4.1.3.2.4.7]
b. 4 Feb 1757 d. 1852
7
Hope Whipple
[1.1.4.1.3.2.5]
b. 12 Aug 1701 d. Bef 28 Oct 1739
Walter Capron
b. 2 Oct 1693 d. Abt 1770
8
Samuel Capron
[1.1.4.1.3.2.5.1]
b. 30 Sep 1722 d. 20 Mar 1745
8
Elkanah Capron
[1.1.4.1.3.2.5.2]
b. 15 Oct 1723 d. Bef 1740
8
Elizabeth Capron
[1.1.4.1.3.2.5.3]
b. 7 Apr 1725 d. 2 Apr 1810
8
Alice Capron
[1.1.4.1.3.2.5.4]
b. 24 Feb 1727
8
Sybil Capron
[1.1.4.1.3.2.5.5]
b. 30 Apr 1730
8
Sylvia Capron
[1.1.4.1.3.2.5.6]
b. 1734 d. 29 Nov 1759
8
William Capron
[1.1.4.1.3.2.5.7]
b. 17 Aug 1736 d. 1796
7
Nathan Whipple
[1.1.4.1.3.2.6]
b. 5 Apr 1704 d. 1 Apr 1725
7
Zachariah Whipple
[1.1.4.1.3.2.7]
b. 2 Feb 1707 d. 1760
Elizabeth Rogers
b. 14 Jun 1706 d. 18 Sep 1751
8
Elizabeth Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.1]
b. 15 Mar 1728
8
Bathasheba Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.2]
b. 6 Jun 1731 d. 1806
John Turner
b. 1725 d. 1817
9
John Turner
[1.1.4.1.3.2.7.2.1]
b. 16 Nov 1751 d. 14 Sep 1814
9
Elizabeth Turner
[1.1.4.1.3.2.7.2.2]
b. 15 Jan 1753
9
Eleanor Turner
[1.1.4.1.3.2.7.2.3]
b. 1755
9
James turner
[1.1.4.1.3.2.7.2.4]
b. 1757
9
Samuel Turner
[1.1.4.1.3.2.7.2.5]
b. 30 Oct 1761 d. Bef 1817
9
Matthew Turner
[1.1.4.1.3.2.7.2.6]
b. 11 Apr 1764
9
Thomas Turner
[1.1.4.1.3.2.7.2.7]
b. 1765 d. 1838
9
Bathsheba Turner
[1.1.4.1.3.2.7.2.8]
b. 11 Nov 1769 d. 8 May 1856
8
Zepaniah Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.3]
b. 3 Feb 1733
8
Alice Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.4]
b. 11 Dec 1734
8
John Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.5]
b. 14 Feb 1738 d. 24 Sep 1753
8
Hope Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6]
b. 7 Feb 1740 d. 28 Mar 1829
Noah Whipple
b. 10 Jan 1742 d. Abt 17 Jun 1774
9
Eunice Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.1]
b. 16 Jun 1764
Comfort Chapman
b. 1760 d. 1786
10
Samuel Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.1.1]
b. 1778 d. 1805
Abiah Waterhouse
b. Abt 1780 d. 1820
11
Samuel Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.1.1.1]
b. 30 Jan 1806 d. 16 Oct 1844
Abiah Crouch
b. 18 Sep 1804 d. 21 Nov 1871
12
Elizabeth Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.1.1.1.1]
b. 21 Jul 1829 d. Dec 1907 [
=>
]
12
John Crouch Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.1.1.1.2]
b. 18 Jun 1832 d. 22 Jan 1893 [
=>
]
12
Daniel Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.1.1.1.3]
b. 18 Jun 1832 d. 5 Nov 1879 [
=>
]
12
Miriam Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.1.1.1.4]
b. 8 Jan 1833 d. 10 Oct 1904 [
=>
]
12
Abiah Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.1.1.1.5]
b. 23 Sep 1834 d. 2 Nov 1911 [
=>
]
12
Mary Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.1.1.1.6]
b. 20 Jul 1836 d. 5 Nov 1879
12
Samuel Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.1.1.1.7]
b. 27 Jul 1838 d. 8 Apr 1862
12
Lucy Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.1.1.1.8]
b. 27 Mar 1842 d. 7 Aug 1842
12
Elias Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.1.1.1.9]
b. 17 Aug 1843 d. 10 Feb 1844
11
Nathan Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.1.1.2]
b. 27 Mar 1807 d. 28 Nov 1885
Hepzibah Whipple
b. 16 Dec 1823 d. 27 Dec 1907
12
Nathan Everett Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.1.1.2.1]
b. 6 Aug 1847 d. 10 May 1910 [
=>
]
12
Jeannette Whipple Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.1.1.2.2]
b. 2 Feb 1852 d. 20 Jan 1894 [
=>
]
12
Mattie Denning Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.1.1.2.3]
b. 12 May 1858 d. 20 Mar 1893 [
=>
]
12
Annie Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.1.1.2.4]
b. 24 Apr 1867 d. 10 Jan 1940 [
=>
]
12
Bertha Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.1.1.2.5]
b. 14 Oct 1868 d. 11 Aug 1938
Mary Watrous
b. 17 Jun 1811 d. 1845
12
Nathan Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.1.1.2.6]
b. 29 Dec 1829 d. 23 Aug 1830
12
Mary Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.1.1.2.7]
b. 24 Jan 1831 d. 5 Jul 1832
12
Phebe Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.1.1.2.8]
b. 6 Nov 1832 d. 16 Apr 1833
12
Mary Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.1.1.2.9]
b. 8 Feb 1834 d. 27 Sep 1834
12
Martha Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.1.1.2.10]
b. 9 Aug 1835 d. 17 Mar 1836
12
Sarah Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.1.1.2.11]
b. 5 Jan 1837 d. 2 Dec 1837
12
Nathan Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.1.1.2.12]
b. 8 Oct 1838 d. 15 Mar 1845
12
Mary D Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.1.1.2.13]
b. Mar 1841 d. 16 Nov 1925 [
=>
]
12
Levi Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.1.1.2.14]
b. 19 Apr 1843 d. 20 Nov 1843
12
Phebe Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.1.1.2.15]
b. 5 Feb 1845 d. 3 May 1845
11
Abiah Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.1.1.3]
b. 18 Oct 1808 d. 8 May 1899
Zephaniah Watrous
b. 30 Oct 1806 d. 10 Jun 1868
12
Zephaniah Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.1.1.3.1]
b. 20 Jan 1829 d. 8 May 1829
12
Abiah Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.1.1.3.2]
b. 2 Jan 1831 d. 24 Sep 1836
12
Zephaniah Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.1.1.3.3]
b. 11 Dec 1835 d. 22 Jul 1836
12
Zephaniah Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.1.1.3.4]
b. 30 Aug 1837 d. 9 Jul 1838
12
Zephaniah Watrous, Jr
[1.1.4.1.3.2.7.6.1.1.3.5]
b. 4 Aug 1839 d. 6 Dec 1861
12
William Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.1.1.3.6]
b. 29 Dec 1841 d. 5 Jul 1842
12
Sarah Elvira Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.1.1.3.7]
b. 3 Jul 1843 d. 26 Jul 1872
12
Nathan Alexander Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.1.1.3.8]
b. 17 May 1846 d. 17 Jun 1860
12
Mary Elizabeth Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.1.1.3.9]
b. 16 Apr 1849 d. 17 May 1860
12
Elias Everett Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.1.1.3.10]
b. 4 Jun 1852 d. 1 Sep 1924 [
=>
]
11
Timothy Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.1.1.4]
b. Mar 1810
11
Ori Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.1.1.5]
b. 18 Sep 1813 d. 1898
Content Whipple
b. 20 Oct 1814 d. 1875
12
Ori Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.1.1.5.1]
b. 1836 d. 7 Apr 1865 [
=>
]
12
Nathan Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.1.1.5.2]
b. 1838 d. 1857
12
Noah Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.1.1.5.3]
b. 1840 d. 26 Apr 1915 [
=>
]
12
Content Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.1.1.5.4]
b. 20 Mar 1842 d. 26 Apr 1915 [
=>
]
12
Betsey Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.1.1.5.5]
b. Abt 1845 d. 9 Jan 1848
12
Abel T Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.1.1.5.6]
b. 30 Mar 1847 d. 15 Dec 1875 [
=>
]
12
Lucy E Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.1.1.5.7]
b. 9 Jan 1848
12
Loran C Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.1.1.5.8]
b. 23 Apr 1850 [
=>
]
12
William Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.1.1.5.9]
b. Abt 1852
10
Betsy Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.1.2]
b. 1787
Epharim Hawley
b. 1762 d. 24 Aug 1850
10
Noah Whaley
[1.1.4.1.3.2.7.6.1.3]
b. 1794
9
Samuel Stillman Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2]
b. 28 Jun 1766 d. 23 Mar 1843
Hephzibah Gates
b. 24 Dec 1765 d. 3 Nov 1822
10
Hephzibah Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.1]
b. 18 Jun 1790 d. 6 Oct 1849
Daniel Watrous
b. 20 Feb 1793 d. 18 Apr 1879
11
Daniel Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.1.1]
b. 10 Oct 1814
11
Hepzibah Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.1.2]
b. 27 Feb 1816 d. 29 Aug 1853
+
Abel Tanner
b. 4 Aug 1805 d. 2 Mar 1899
11
Elizabeth Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.1.3]
b. 7 Jun 1817 d. 6 Nov 1888
Samuel Gates Whipple
b. 1 Feb 1817 d. 15 Feb 1904
12
Elizabeth Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.1.3.1]
b. 13 Feb 1839 d. 26 Nov 1844
12
Albert Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.1.3.2]
b. 6 May 1840 d. 4 Mar 1920 [
=>
]
12
Hepzibah Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.1.3.3]
b. 29 Oct 1841 d. 19 Jul 1847
12
Cyrus Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.1.3.4]
b. 22 Mar 1843 d. 10 Jun 1843
12
James Eldon Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.1.3.5]
b. 5 Nov 1847 d. 27 May 1923 [
=>
]
12
Sarah Lavina Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.1.3.6]
b. 8 Dec 1849 d. 7 Nov 1877 [
=>
]
12
Olive Estelle Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.1.3.7]
b. 25 Feb 1852 d. 25 Nov 1918
12
Martha Josephine Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.1.3.8]
b. 2 May 1853 d. 16 Apr 1942 [
=>
]
12
Daniel Joash Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.1.3.9]
b. 17 Jul 1855 d. 24 Feb 1933 [
=>
]
12
Clarissa Isabel Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.1.3.10]
b. 5 Sep 1857 d. 21 Feb 1930 [
=>
]
11
Daniel Watrous, Jr
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.1.4]
b. 16 Apr 1819 d. 29 Apr 1886
Phebe Whipple
b. 8 Aug 1822 d. 28 Dec 1850
12
Emeline Matilda Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.1.4.1]
b. 14 Mar 1847 d. 9 Apr 1853
12
Daniel Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.1.4.2]
b. Abt 1850
+
Content Watrous
b. 19 Oct 1835 d. 27 Nov 1854
Lucy Watrous
b. 28 Mar 1837 d. 23 Oct 1863
12
Silas Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.1.4.3]
b. 5 Mar 1860 d. 1 Feb 1904
12
Daniel E Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.1.4.4]
b. 5 Mar 1860 d. 1 Feb 1904 [
=>
]
+
Rachel Crouch
b. 29 Apr 1824 d. 28 Aug 1897
11
Fanny Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.1.5]
b. Feb 1821 d. 27 Nov 1900
Noah Whipple
b. 21 Jan 1816 d. 23 Sep 1881
12
Edwin Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.1.5.1]
b. 11 Aug 1839 d. 7 Apr 1857
12
Austin Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.1.5.2]
b. 8 Dec 1843 d. 12 May 1863
12
Urban Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.1.5.3]
b. Abt 1845 d. 28 Feb 1899 [
=>
]
12
Warren Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.1.5.4]
b. 10 May 1846 d. 20 Feb 1853
12
Dudley Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.1.5.5]
b. 10 Nov 1847 d. 22 Feb 1853
12
Hiram Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.1.5.6]
b. 20 Sep 1852 d. 9 Jul 1930 [
=>
]
12
Almeda Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.1.5.7]
b. 24 Sep 1854 d. 16 Sep 1856
12
Dudley Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.1.5.8]
b. 5 Dec 1856 d. 9 Dec 1859
11
Mary Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.1.6]
b. 9 Jan 1823 d. 27 May 1846
11
James Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.1.7]
b. 15 Feb 1825 d. 19 Jul 1903
Hannah Watrous
b. 31 Dec 1832 d. 7 Nov 1884
12
Angelina Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.1.7.1]
b. 11 Jul 1852 d. Jun 1888 [
=>
]
12
Mary Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.1.7.2]
b. 8 Nov 1853 d. 13 Oct 1927 [
=>
]
12
Lucy Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.1.7.3]
b. 26 Jul 1855 d. 1938 [
=>
]
12
Lunette Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.1.7.4]
b. 30 May 1857 d. 6 Jan 1921
12
James Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.1.7.5]
b. 26 Sep 1858 d. 7 Aug 1921 [
=>
]
12
Stephen H Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.1.7.6]
b. 17 Jul 1864 d. 26 May 1930 [
=>
]
12
Ernest Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.1.7.7]
b. 10 Sep 1870 d. 24 Mar 1930
11
Nathan Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.1.8]
b. 15 Oct 1827 d. 26 Dec 1827
11
Nathan Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.1.9]
b. 25 Oct 1828 d. 6 Oct 1890
Phebe Ann Mitchell
b. 1833 d. 4 Apr 1895
12
Erastus Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.1.9.1]
b. 5 Oct 1854 d. 17 Mar 1925 [
=>
]
12
Phebe Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.1.9.2]
b. 1 Sep 1856 d. 5 Jan 1945
12
Caroline Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.1.9.3]
b. 7 Jan 1867 d. 17 Apr 1945
12
Austin Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.1.9.4]
b. 21 Jul 1869 d. 29 May 1941
11
Sarah Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.1.10]
b. 26 Feb 1831 d. 11 May 1869
Jabez Crouch, Jr
b. 4 Nov 1833
12
Walter L Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.1.10.1]
b. 5 Jan 1859
12
Lorenzo Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.1.10.2]
b. 11 Feb 1860 d. 26 Aug 1891
12
Sarah Annie Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.1.10.3]
b. 30 Apr 1865 bur. 1 Jan 1904 [
=>
]
10
Noah Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2]
b. 6 Apr 1792 d. 26 Oct 1871
Content Crouch
b. 5 Oct 1794 d. 30 Apr 1835
11
Content Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.1]
b. 20 Oct 1814 d. 1875
Ori Chapman
b. 18 Sep 1813 d. 1898
12
Ori Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.1.1]
b. 1836 d. 7 Apr 1865 [
=>
]
12
Nathan Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.1.2]
b. 1838 d. 1857
12
Noah Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.1.3]
b. 1840 d. 26 Apr 1915 [
=>
]
12
Content Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.1.4]
b. 20 Mar 1842 d. 26 Apr 1915 [
=>
]
12
Betsey Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.1.5]
b. Abt 1845 d. 9 Jan 1848
12
Abel T Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.1.6]
b. 30 Mar 1847 d. 15 Dec 1875 [
=>
]
12
Lucy E Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.1.7]
b. 9 Jan 1848
12
Loran C Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.1.8]
b. 23 Apr 1850 [
=>
]
12
William Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.1.9]
b. Abt 1852
11
Noah Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.2]
b. 21 Jan 1816 d. 23 Sep 1881
Fanny Watrous
b. Feb 1821 d. 27 Nov 1900
12
Edwin Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.2.1]
b. 11 Aug 1839 d. 7 Apr 1857
12
Austin Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.2.2]
b. 8 Dec 1843 d. 12 May 1863
12
Urban Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.2.3]
b. Abt 1845 d. 28 Feb 1899 [
=>
]
12
Warren Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.2.4]
b. 10 May 1846 d. 20 Feb 1853
12
Dudley Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.2.5]
b. 10 Nov 1847 d. 22 Feb 1853
12
Hiram Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.2.6]
b. 20 Sep 1852 d. 9 Jul 1930 [
=>
]
12
Almeda Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.2.7]
b. 24 Sep 1854 d. 16 Sep 1856
12
Dudley Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.2.8]
b. 5 Dec 1856 d. 9 Dec 1859
11
Samuel Gates Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.3]
b. 1 Feb 1817 d. 15 Feb 1904
Elizabeth Watrous
b. 7 Jun 1817 d. 6 Nov 1888
12
Elizabeth Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.3.1]
b. 13 Feb 1839 d. 26 Nov 1844
12
Albert Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.3.2]
b. 6 May 1840 d. 4 Mar 1920 [
=>
]
12
Hepzibah Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.3.3]
b. 29 Oct 1841 d. 19 Jul 1847
12
Cyrus Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.3.4]
b. 22 Mar 1843 d. 10 Jun 1843
12
James Eldon Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.3.5]
b. 5 Nov 1847 d. 27 May 1923 [
=>
]
12
Sarah Lavina Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.3.6]
b. 8 Dec 1849 d. 7 Nov 1877 [
=>
]
12
Olive Estelle Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.3.7]
b. 25 Feb 1852 d. 25 Nov 1918
12
Martha Josephine Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.3.8]
b. 2 May 1853 d. 16 Apr 1942 [
=>
]
12
Daniel Joash Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.3.9]
b. 17 Jul 1855 d. 24 Feb 1933 [
=>
]
12
Clarissa Isabel Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.3.10]
b. 5 Sep 1857 d. 21 Feb 1930 [
=>
]
11
Amos Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.4]
b. 12 Aug 1818 d. 7 Aug 1894
Sarah "Sally" Whipple
b. 28 Nov 1822 d. 11 Jul 1887
12
William Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.4.1]
b. Abt 1840 d. Abt 1840
12
Sarah Jane Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.4.2]
b. 30 May 1842 d. 29 Jul 1887 [
=>
]
12
Pamelia Maria Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.4.3]
b. 21 May 1845 d. 29 May 1896 [
=>
]
12
Amos L Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.4.4]
b. 4 Aug 1849 d. Bef 1859
11
William Crouch Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.5]
b. 3 Oct 1819 d. 30 Oct 1906
Hannah Cordelia Geer
b. 11 Aug 1823 d. 10 Sep 1904
12
Louisa Ann Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.5.1]
b. 10 Aug 1841 d. 27 Feb 1902 [
=>
]
12
Phoebe Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.5.2]
b. 1843 d. Abt 1854
12
Oliver David Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.5.3]
b. 1845 d. 1860
12
Noyce Palmer Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.5.4]
b. Abt 1845 d. 1847
12
Carrie Thornton Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.5.5]
b. Abt 1847 d. 1847
12
Amos Geer "Owen" Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.5.6]
b. Mar 1847 d. 14 May 1872
12
Orin Pierce Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.5.7]
b. 18 Apr 1851 d. 13 Sep 1904 [
=>
]
12
Orva Lester Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.5.8]
b. 27 Nov 1857 d. 30 Oct 1931 [
=>
]
12
Oscar Yates Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.5.9]
b. 7 Jun 1859 d. 20 Dec 1935 [
=>
]
12
Hannah Odella Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.5.10]
b. 7 Oct 1863 d. 22 Jul 1929 [
=>
]
12
Lawence Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.5.11]
b. 24 Feb 1868 d. 1917 [
=>
]
12
Earnest William Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.5.12]
b. 31 Jul 1868 d. 8 Jun 1939 [
=>
]
11
John Bolles Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.6]
b. 24 Nov 1820 d. 14 Feb 1870
Mary Ann Whipple
b. 1 Jul 1820 d. 6 Mar 1894
12
Harriet Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.6.1]
b. 18 May 1843 d. 23 Oct 1897 [
=>
]
12
Mary Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.6.2]
b. 1845
12
Christina Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.6.3]
b. 1847 d. 1856
12
Eliza Jane Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.6.4]
b. 1849 d. 1864
12
Lucy Emma Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.6.5]
b. 17 Apr 1850 d. 8 Aug 1915 [
=>
]
12
Phebe Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.6.6]
b. Abt 1851 d. Abt 1852
12
Alden Avery Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.6.7]
b. Abt 1853 d. 1867
12
Noah Avery Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.6.8]
b. Abt 1855 d. Abt 1867
12
Hannah Adelia Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.6.9]
b. 22 Oct 1856 d. 29 Jul 1934 [
=>
]
12
John Franklin Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.6.10]
b. 14 Jul 1863 d. 5 Mar 1903
11
Lucy Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.7]
b. 24 Nov 1820 d. 13 Apr 1894
Jonathan Crouch Whipple
b. 2 Apr 1821 d. 13 Apr 1885
12
Lucy Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.7.1]
b. 24 Feb 1843 d. Nov 1848
12
Content Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.7.2]
b. 27 Jun 1844 d. 25 Oct 1880 [
=>
]
12
Lucy Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.7.3]
b. 4 Dec 1848
12
Zerah Colburn Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.7.4]
b. 1 Sep 1849 d. 12 Sep 1879 [
=>
]
12
Laura Bridgeman Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.7.5]
b. 9 Apr 1852 d. 14 Aug 1915 [
=>
]
12
Walter Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.7.6]
b. 17 Apr 1854 d. 3 Oct 1876
11
Phebe Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.8]
b. 8 Aug 1822 d. 28 Dec 1850
Daniel Watrous, Jr
b. 16 Apr 1819 d. 29 Apr 1886
12
Emeline Matilda Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.8.1]
b. 14 Mar 1847 d. 9 Apr 1853
12
Daniel Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.8.2]
b. Abt 1850
11
Hepzibah Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.9]
b. 16 Dec 1823 d. 27 Dec 1907
Nathan Chapman
b. 27 Mar 1807 d. 28 Nov 1885
12
Nathan Everett Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.9.1]
b. 6 Aug 1847 d. 10 May 1910 [
=>
]
12
Jeannette Whipple Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.9.2]
b. 2 Feb 1852 d. 20 Jan 1894 [
=>
]
12
Mattie Denning Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.9.3]
b. 12 May 1858 d. 20 Mar 1893 [
=>
]
12
Annie Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.9.4]
b. 24 Apr 1867 d. 10 Jan 1940 [
=>
]
12
Bertha Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.9.5]
b. 14 Oct 1868 d. 11 Aug 1938
11
Cyrus Field Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.10]
b. 5 Mar 1825 d. 22 Jun 1911
Delight Whipple
b. 29 Apr 1824 d. 3 Feb 1859
12
Cyrus Evin Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.10.1]
b. 14 Oct 1847 d. 12 Mar 1941 [
=>
]
12
Amos E Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.10.2]
b. 21 Dec 1848 d. 13 Feb 1850
12
Delight Malvina Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.10.3]
b. 21 Sep 1850 d. 15 Oct 1871
12
Hepzibah Ursula Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.10.4]
b. 14 Oct 1852
12
Wylie Anderson Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.10.5]
b. 18 Feb 1855 d. 14 Nov 1922
12
Annette Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.10.6]
b. 3 Feb 1859 d. 11 Dec 1933 [
=>
]
Louise Harriet Rich
b. 29 Mar 1841 d. 13 Dec 1889
12
Estella Louise Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.10.7]
b. 20 Jan 1874 d. 20 Dec 1953 [
=>
]
12
Jennie May Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.10.8]
b. 10 Aug 1875
11
Betsey Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.11]
b. 28 Oct 1826 d. 10 Jan 1902
Timothy Crouch
b. 2 Mar 1826 d. 25 Jan 1874
12
Levi William Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.11.1]
b. 29 May 1848 d. 8 Sep 1920 [
=>
]
12
Timothy A Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.11.2]
b. 2 Jan 1849 d. 16 Sep 1850
12
Frederick Nelson Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.11.3]
b. 6 Aug 1851 d. 17 Mar 1923 [
=>
]
12
Joseph Solomon Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.11.4]
b. 3 Oct 1853 d. 20 May 1946 [
=>
]
12
Courtland M Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.11.5]
b. 10 Jan 1855 d. 14 Oct 1859
12
Franklin P Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.11.6]
b. 8 Jan 1861 d. 24 Mar 1862
12
Edwin Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.11.7]
b. 22 Nov 1863 d. 10 Aug 1864
12
Phebe Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.11.8]
b. 16 Feb 1865 d. 11 May 1868
12
Daniel Elmer Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.11.9]
b. 4 Jan 1868 d. 17 Mar 1955 [
=>
]
12
Samuel Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.11.10]
b. 4 Jan 1868
12
Cynthia Betsey Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.11.11]
b. 16 Aug 1871 d. 20 Jun 1930 [
=>
]
12
Alden Avery Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.11.12]
b. 27 Dec 1856 d. 2 Mar 1932 [
=>
]
+
Ichabod Davis, Jr
b. 21 Mar 1824 d. 16 Oct 1907
11
Joseph Francis Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.12]
b. 13 Jan 1828 d. 6 Sep 1864
11
David Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.13]
b. 8 Jul 1829 d. 29 Jan 1912
Lydia Ann Douglas
b. 12 Mar 1825 d. 20 May 1880
12
Elenora Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.13.1]
b. 28 Feb 1852 d. 11 Aug 1868
12
Gershom Douglas Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.13.2]
b. 7 Jul 1853 d. 28 Jan 1931 [
=>
]
12
Etiole Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.13.3]
b. 6 Apr 1858 d. 28 Jan 1931 [
=>
]
12
Frances M Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.13.4]
b. 18 Feb 1862 d. 12 Aug 1945
12
Bryant Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.13.5]
b. 1864 d. 4 Aug 1868
12
Frederick Merrit Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.13.6]
b. 6 Mar 1869
Jesse Scott
b. 15 Apr 1857 d. 3 Oct 1931
12
Larrabee Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.13.7]
b. 5 Jul 1887
12
Otis Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.13.8]
b. 17 Jul 1890 d. Sep 1982
12
Sidney Herman Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.13.9]
b. 17 Sep 1899 d. Mar 1981
11
Esther Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.14]
b. 16 Sep 1830 d. 14 Aug 1905
Elijah Fitch
b. 15 Jan 1832 d. 13 Feb 1897
12
Ettie Fitch
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.14.1]
b. Abt 1851
12
Ella Hepsie Fitch
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.14.2]
b. 6 Mar 1854
12
Emmogene Fitch
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.14.3]
b. 3 May 1857 d. 11 Nov 1920 [
=>
]
12
Elijah A Fitch
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.14.4]
b. 17 Jul 1859 d. 18 Nov 1929 [
=>
]
12
Chester Lewis Fitch
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.14.5]
b. 9 Nov 1866
12
Lula Medora Fitch
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.14.6]
b. 15 Oct 1868 d. 9 Dec 1917 [
=>
]
11
Zachariah Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.15]
b. 2 Feb 1832 d. 26 Mar 1917
Mary Crouch
b. Abt 1836 d. 18 Nov 1913
12
George Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.15.1]
b. 17 Apr 1857 d. 13 Nov 1919
12
Florence A Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.15.2]
b. 22 Mar 1859 d. 4 Oct 1861
12
Palmer Gates Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.15.3]
b. 1 May 1861 d. 3 Feb 1932
12
Allen Judson Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.15.4]
b. 29 Aug 1863 d. 23 Dec 1941 [
=>
]
12
Laura E Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.15.5]
b. 16 Aug 1865 d. 5 Apr 1872
12
Cynthia Ada Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.15.6]
b. 26 Sep 1868 d. 22 Feb 1907 [
=>
]
12
Julius Zachariah Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.15.7]
b. 28 Aug 1873 d. 18 Oct 1879
11
Rebecca Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.16]
b. 16 Sep 1833 d. 11 Sep 1835
11
Silas Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.17]
b. 29 Apr 1835 d. 28 Apr 1836
Christian "Christina" Crouch
b. 23 Oct 1799 d. 5 Jul 1884
11
Miriam Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.18]
b. 30 May 1836 d. 3 Jul 1836
11
Rebecca Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.19]
b. 26 Jun 1837 d. 31 Jul 1887
Nelson Hammond
b. 30 Apr 1826 d. 14 Nov 1905
12
Albert Nelson Hammond
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.19.1]
b. 17 Dec 1858 d. 19 Nov 1945 [
=>
]
12
Alice Rebecca Hammond
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.19.2]
b. 10 Jul 1861 d. Feb 1942
12
Flora Evelyn Hammond
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.19.3]
b. 31 May 1875
11
Harriet Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.20]
b. 12 Feb 1840 d. 20 Mar 1843
11
Margaret Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.21]
b. 27 Sep 1842 d. 31 Jan 1914
Josiah Hammond
b. 21 Apr 1821 d. 25 Jan 1895
12
Clara Maria Hammond
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.21.1]
b. 21 Aug 1863 d. 1 Feb 1964 [
=>
]
12
Freddie Josiah Hammond
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.21.2]
b. 1 Dec 1872 d. 15 May 1873
11
Charles Plyman Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.22]
b. 11 Nov 1845 d. 25 Jan 1919
Harriet Ardelia Olin
b. 29 Sep 1847 d. 28 Oct 1892
12
Harriet Ermina Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.22.1]
b. 15 Nov 1866 d. 15 Feb 1905 [
=>
]
12
Charles Nelson Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.22.2]
b. 5 Jan 1869 d. 9 Jan 1876
12
Arthur Clarence Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.22.3]
b. 10 Apr 1872 d. 15 Oct 1936 [
=>
]
12
Oscar Wesley Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.22.4]
b. 7 Jan 1874 d. 15 Jan 1943 [
=>
]
12
Nellie Christina Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.22.5]
b. 1 Dec 1875 d. 27 Jan 1953
12
Addie Isabel Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.22.6]
b. 11 Nov 1879 d. 17 Aug 1945
12
Charles Horton Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.22.7]
b. 30 Oct 1880
12
Mabel Spofford Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.2.22.8]
b. 9 May 1885 d. Jul 1969
10
Jonathan Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.3]
b. 14 Aug 1794 d. 11 Feb 1875
Elizabeth Crouch
b. 26 Jun 1796 d. 26 Nov 1883
11
Elizabeth Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.3.1]
b. 2 Nov 1816 d. 2 Sep 1881
David Crouch
b. 7 Jun 1806 d. 25 May 1891
12
Elizabeth Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.3.1.1]
b. 8 Jan 1834 d. 3 Feb 1834
12
Mary Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.3.1.2]
b. Abt 1836 d. 18 Nov 1913 [
=>
]
12
Elizabeth Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.3.1.3]
b. 9 Jan 1838 d. 1842
12
Allen Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.3.1.4]
b. 18 Jan 1839 d. 12 Jan 1922 [
=>
]
12
Abbie Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.3.1.5]
b. 20 Apr 1841 d. 15 Aug 1931 [
=>
]
12
Elizabeth Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.3.1.6]
b. 28 Apr 1843 d. 13 Aug 1930 [
=>
]
12
David Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.3.1.7]
b. 17 Mar 1845 d. 1845
12
Enoch Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.3.1.8]
b. 29 Apr 1846 d. 2 Jun 1905 [
=>
]
12
Nathan Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.3.1.9]
b. 5 Jul 1848 d. 12 Nov 1933 [
=>
]
12
Lucy Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.3.1.10]
b. 25 Jun 1850 d. 23 May 1906 [
=>
]
12
Emma Caroline Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.3.1.11]
b. 21 Jul 1852 d. 23 May 1906 [
=>
]
12
Alice Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.3.1.12]
b. 17 May 1854 d. Jul 1854
12
Alice Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.3.1.13]
b. 2 Jun 1855 d. 4 Dec 1865
11
Mary Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.3.2]
b. 15 Jun 1818 d. 7 Oct 1897
William M Waley
b. Abt 1818
12
Gilbert Gard "Gard" Waley
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.3.2.1]
b. 1 Jun 1853 d. 14 Jan 1918 [
=>
]
11
Jonathan Crouch Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.3.3]
b. 2 Apr 1821 d. 13 Apr 1885
Lucy Whipple
b. 24 Nov 1820 d. 13 Apr 1894
12
Lucy Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.3.3.1]
b. 24 Feb 1843 d. Nov 1848
12
Content Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.3.3.2]
b. 27 Jun 1844 d. 25 Oct 1880 [
=>
]
12
Lucy Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.3.3.3]
b. 4 Dec 1848
12
Zerah Colburn Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.3.3.4]
b. 1 Sep 1849 d. 12 Sep 1879 [
=>
]
12
Laura Bridgeman Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.3.3.5]
b. 9 Apr 1852 d. 14 Aug 1915 [
=>
]
12
Walter Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.3.3.6]
b. 17 Apr 1854 d. 3 Oct 1876
11
Abby Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.3.4]
b. 16 May 1823 d. 3 Jan 1859
+
John Rogers Whipple
b. 18 Dec 1825 d. 23 Sep 1878
11
Enoch Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.3.5]
b. 15 Mar 1825 d. 7 Oct 1897
Delight Crouch
b. 27 Mar 1835 d. 30 Jan 1905
12
Alice Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.3.5.1]
b. 4 Nov 1852 d. 18 Dec 1852
12
Abilier Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.3.5.2]
b. 10 Nov 1853 d. 1 Dec 1853
12
George Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.3.5.3]
b. 9 Mar 1857 d. 25 Apr 1857
12
George Alfred Montgomery
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.3.5.4]
b. Sep 1861 d. 1932 [
=>
]
10
Jabez Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4]
b. 15 Apr 1796 d. 14 Dec 1870
Mary "Polly" Watrous
b. 12 Jan 1799 d. 3 Jun 1820
11
Jabez Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4.1]
b. 12 Aug 1818 d. 1 May 1875
Harriet Ann Whipple
b. 24 Sep 1821 d. 27 Jul 1869
12
Horace Greely Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4.1.1]
b. 27 Jan 1849 d. 22 Jun 1883
12
Augustus Newcomb Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4.1.2]
b. 12 Jul 1851 d. 5 Jan 1934
12
Ossean Walter Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4.1.3]
b. 15 Nov 1853 d. 23 Aug 1855
12
Jemma Clarence Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4.1.4]
b. 26 May 1856 d. 16 May 1857
12
Eddie Clarence Walter Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4.1.5]
b. 16 Oct 1858 d. 5 Jan 1877
12
Harriet Maria Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4.1.6]
b. 1 Aug 1863 d. 9 Jul 1874
Sarah "Sally" Watrous
b. 16 Nov 1798 d. 13 Sep 1838
11
Timothy Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4.2]
b. 3 Sep 1821 d. 11 Jan 1892
Lucy Ann Geer
b. 5 Jul 1825 d. 14 Feb 1884
12
Timothy Geer Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4.2.1]
b. 4 Oct 1843 d. 11 Oct 1844
12
Lucy Anna Geer Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4.2.2]
b. 6 Oct 1845 d. 6 Nov 1846
12
Daughter Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4.2.3]
b. 10 Sep 1846
12
Daughter Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4.2.4]
b. 10 Sep 1848 d. Aft 10 Sep 1848
12
Ida Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4.2.5]
b. 5 Jan 1849 d. 21 May 1903
12
Phoebe Nellie Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4.2.6]
b. 6 May 1851 d. 17 Jun 1871 [
=>
]
12
Timothy Thomas Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4.2.7]
b. 22 Nov 1853 d. 16 Aug 1936
12
Asher Avery Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4.2.8]
b. 6 Apr 1856 d. 27 Apr 1860
12
Silas Stillman Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4.2.9]
b. 4 Apr 1859 d. 12 Jan 1935 [
=>
]
12
Annie Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4.2.10]
b. 11 Feb 1862 d. 12 Aug 1863
12
Samuel Austin Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4.2.11]
b. 23 Nov 1864 d. 6 Feb 1922 [
=>
]
12
Thomas Geer Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4.2.12]
b. 8 Dec 1867 d. 29 Jul 1949 [
=>
]
12
Christine Violet Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4.2.13]
b. 13 Feb 1871 d. 25 Jun 1912 [
=>
]
11
Sarah "Sally" Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4.3]
b. 28 Nov 1822 d. 11 Jul 1887
Amos Whipple
b. 12 Aug 1818 d. 7 Aug 1894
12
William Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4.3.1]
b. Abt 1840 d. Abt 1840
12
Sarah Jane Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4.3.2]
b. 30 May 1842 d. 29 Jul 1887 [
=>
]
12
Pamelia Maria Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4.3.3]
b. 21 May 1845 d. 29 May 1896 [
=>
]
12
Amos L Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4.3.4]
b. 4 Aug 1849 d. Bef 1859
11
Nathan Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4.4]
b. 20 Jul 1824 d. 6 Mar 1889
Thankful Amela Geer
b. 18 Feb 1827 d. 11 Dec 1895
12
Julia Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4.4.1]
b. 2 Sep 1846 d. 17 Apr 1848
12
Nathan Franklin Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4.4.2]
b. 2 Sep 1847 d. 12 Feb 1908 [
=>
]
12
Julie Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4.4.3]
b. 8 Aug 1848
12
Lewis DeWayne Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4.4.4]
b. 27 May 1849 d. 13 Feb 1919 [
=>
]
12
Edith Lillian Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4.4.5]
b. 1853 d. 17 Nov 1881 [
=>
]
12
Alice Estalina "Lina" Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4.4.6]
b. 17 Dec 1861 d. 15 Oct 1903
11
Ira Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4.5]
b. 9 Apr 1826 d. 29 Apr 1831
11
Mary Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4.6]
b. 25 Dec 1827 d. 13 Aug 1876
Ichabod Davis, Jr
b. 21 Mar 1824 d. 16 Oct 1907
12
Elisha Davis
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4.6.1]
b. 3 Dec 1846 d. 8 Mar 1854
12
Elias Davis
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4.6.2]
b. 12 Mar 1849
12
Helen Thwing Davis
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4.6.3]
b. 16 Mar 1855 d. 17 May 1856
12
Franklin Herbert Davis
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4.6.4]
b. 1 Dec 1858 d. 21 Mar 1859
11
Hannah Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4.7]
b. 27 Dec 1829 d. 19 Dec 1865
Dudley Bailey Chapman
b. 23 Apr 1825 d. 1895
12
Hannah Amelia Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4.7.1]
b. 6 Feb 1847
12
Alice Burton Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4.7.2]
b. 19 Mar 1850 d. 15 Jun 1881
12
Eva Louise Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4.7.3]
b. 10 Apr 1852 d. 8 Feb 1900 [
=>
]
11
Nancy Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4.8]
b. 16 Jul 1831 d. Jan 1894
+
William Robert Lewers
b. 19 Apr 1829 d. 10 Jul 1865
11
Ira Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4.9]
b. 14 Jan 1834 d. 9 Apr 1903
Martha Crouch
b. 13 Mar 1839 d. 13 May 1885
12
Frederick Enoch Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4.9.1]
b. 21 Mar 1861 d. 9 Jun 1939
12
Clara Helen Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4.9.2]
b. 5 Mar 1864 d. 1947
12
Harry William Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4.9.3]
b. 5 Dec 1867 d. 9 Sep 1943
12
Rose Emmeline Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4.9.4]
b. 21 Jan 1870 d. 27 Jul 1962
11
Hepzibah Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4.10]
b. 27 Dec 1835 d. Abt 1836
11
Silas Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4.11]
b. 26 Apr 1837 d. Abt Jul 1837
11
Elisha Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.4.12]
b. 23 Jul 1838 d. Abt Sep 1838
10
Samuel Stillman Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.5]
b. 30 Mar 1798 d. 5 Jun 1836
Harriet Cushman
b. 1794 d. 11 Aug 1836
11
Samuel Stillman Whipple, III
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.5.1]
b. 24 Jun 1820 d. 7 Jun 1848
Julia Watrous
b. 4 Mar 1819 d. 26 Sep 1844
12
Samuel Stillman Whipple, IV
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.5.1.1]
b. 1843 d. 1 Jun 1864
+
Matilda Watrous
b. 1824
11
Harriet Ann Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.5.2]
b. 24 Sep 1821 d. 27 Jul 1869
Jabez Whipple
b. 12 Aug 1818 d. 1 May 1875
12
Horace Greely Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.5.2.1]
b. 27 Jan 1849 d. 22 Jun 1883
12
Augustus Newcomb Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.5.2.2]
b. 12 Jul 1851 d. 5 Jan 1934
12
Ossean Walter Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.5.2.3]
b. 15 Nov 1853 d. 23 Aug 1855
12
Jemma Clarence Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.5.2.4]
b. 26 May 1856 d. 16 May 1857
12
Eddie Clarence Walter Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.5.2.5]
b. 16 Oct 1858 d. 5 Jan 1877
12
Harriet Maria Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.5.2.6]
b. 1 Aug 1863 d. 9 Jul 1874
11
Paul Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.5.3]
b. 23 Dec 1822 d. 1868
Christian Crouch
b. 1824
12
Mary Christian Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.5.3.1]
b. 1846 d. 11 Aug 1876 [
=>
]
12
Paul Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.5.3.2]
b. 10 Aug 1847 d. 1890
12
Hannah Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.5.3.3]
b. 1848 d. 8 Mar 1882
12
Miriam Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.5.3.4]
b. 2 May 1849
12
Harvey Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.5.3.5]
b. Abt 1852 d. 1 Aug 1894
12
Ida Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.5.3.6]
b. 1856 d. 1887
12
Allen Gates Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.5.3.7]
b. 3 Sep 1857 d. 15 Jun 1936 [
=>
]
12
Harriet Elizabeth Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.5.3.8]
b. Abt 1859
11
Delight Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.5.4]
b. 29 Apr 1824 d. 3 Feb 1859
Cyrus Field Whipple
b. 5 Mar 1825 d. 22 Jun 1911
12
Cyrus Evin Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.5.4.1]
b. 14 Oct 1847 d. 12 Mar 1941 [
=>
]
12
Amos E Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.5.4.2]
b. 21 Dec 1848 d. 13 Feb 1850
12
Delight Malvina Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.5.4.3]
b. 21 Sep 1850 d. 15 Oct 1871
12
Hepzibah Ursula Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.5.4.4]
b. 14 Oct 1852
12
Wylie Anderson Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.5.4.5]
b. 18 Feb 1855 d. 14 Nov 1922
12
Annette Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.5.4.6]
b. 3 Feb 1859 d. 11 Dec 1933 [
=>
]
11
John Rogers Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.5.5]
b. 18 Dec 1825 d. 23 Sep 1878
+
Abby Whipple
b. 16 May 1823 d. 3 Jan 1859
+
Harriet Clark
b. Abt 1825
11
Jeduthan Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.5.6]
b. 31 Oct 1827 d. 25 Nov 1920
11
Stephen Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.5.7]
b. 16 Apr 1830 d. 31 May 1830
11
Stephen Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.5.8]
b. 2 Apr 1831 d. 24 May 1832
11
Daniel Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.5.9]
b. 27 Aug 1833 d. 21 May 1839
11
Maria Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.5.10]
b. 28 May 1835
James W Howard
b. 1827
12
James William Howard
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.5.10.1]
b. 5 Apr 1852 d. 13 Aug 1929 [
=>
]
12
Hattie Howard
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.5.10.2]
b. 3 Dec 1855 [
=>
]
12
Julia A Howard
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.5.10.3]
b. 4 Feb 1859 d. 1942 [
=>
]
10
Elizabeth Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.6]
b. 19 Apr 1800 d. 20 Nov 1882
Ichabod Davis
b. 9 Aug 1799 d. 17 Sep 1871
11
Ichabod Davis
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.6.1]
b. 14 Aug 1821 d. 15 Aug 1821
11
Elizabeth "Eliza" Davis
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.6.2]
b. 29 Jul 1822 d. 4 Feb 1904
Stephen Wilkinson Murphy
b. 23 Mar 1817 d. 3 Jun 1881
12
Stephen Wilkinson Murphy
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.6.2.1]
b. 27 Feb 1843 d. 25 Sep 1843
12
Stephen Wilkinson Murphy
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.6.2.2]
b. 4 Jun 1846 d. 13 Sep 1846
12
Stephen Wilkinson Murphy
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.6.2.3]
b. 13 Jan 1848 d. 10 Aug 1848
12
Eliza Jane Murphy
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.6.2.4]
b. 6 Jan 1850 d. 12 Nov 1878 [
=>
]
12
Anson Avery Murphy
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.6.2.5]
b. 16 Mar 1854 d. 6 Jun 1858
12
Annie Avery Murphy
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.6.2.6]
b. 8 Jun 1858 d. 28 Aug 1938 [
=>
]
+
William Lamphere
b. 23 May 1812 d. 9 Jul 1897
11
Ichabod Davis, Jr
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.6.3]
b. 21 Mar 1824 d. 16 Oct 1907
Mary Whipple
b. 25 Dec 1827 d. 13 Aug 1876
12
Elisha Davis
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.6.3.1]
b. 3 Dec 1846 d. 8 Mar 1854
12
Elias Davis
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.6.3.2]
b. 12 Mar 1849
12
Helen Thwing Davis
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.6.3.3]
b. 16 Mar 1855 d. 17 May 1856
12
Franklin Herbert Davis
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.6.3.4]
b. 1 Dec 1858 d. 21 Mar 1859
+
Betsey Whipple
b. 28 Oct 1826 d. 10 Jan 1902
11
Frances Davis
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.6.4]
b. 15 Mar 1826 d. 28 May 1900
George Washington Avery
b. 9 Oct 1824 d. 16 Dec 1905
12
George Washington Avery, Jr
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.6.4.1]
b. 18 Feb 1847 d. 15 Feb 1928 [
=>
]
12
Ellen Frances Avery
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.6.4.2]
b. 1852 d. 1912
12
Charles Franklin Avery
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.6.4.3]
b. 19 Apr 1854 [
=>
]
12
Herbert Lincoln Avery
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.6.4.4]
b. 4 Apr 1867
11
Julia Ann Davis
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.6.5]
b. 28 Feb 1828 d. 16 Sep 1907
George Burrows Park
b. 16 May 1816 d. 11 Mar 1908
12
Elvie Julia Park
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.6.5.1]
b. 26 Dec 1856 d. 2 Feb 1905 [
=>
]
12
Elisha C Park
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.6.5.2]
b. 31 Jan 1865 d. 28 Aug 1866
12
William George Park
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.6.5.3]
b. 24 May 1867 d. 6 Apr 1944
11
Delia Content Davis
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.6.6]
b. 20 Jan 1830 d. 21 May 1893
John Henry Rogers
b. 1820 d. 23 Sep 1874
12
Delia Ann Rogers
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.6.6.1]
b. 21 Mar 1847 d. 10 Apr 1895
12
John Lovejoy Rogers
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.6.6.2]
b. 8 Apr 1849
12
Angeline Amelia "Angie" Rogers
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.6.6.3]
b. 11 May 1852 d. 6 Dec 1911
12
Henry Morgan Rogers
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.6.6.4]
b. 12 Sep 1860
12
Ella Alberta Rogers
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.6.6.5]
b. 15 Aug 1866 d. 10 Apr 1895 [
=>
]
+
Miner Allen
b. Abt 1828
11
Hannah Melissa Davis
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.6.7]
b. 15 Dec 1832 d. 26 Feb 1911
Park Avery
b. 21 Feb 1829 d. 24 Oct 1912
12
Edgar Lincoln Avery
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.6.7.1]
b. 23 Apr 1854 d. 31 Oct 1906 [
=>
]
12
Fannie Elizabeth Avery
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.6.7.2]
b. 21 Mar 1858 d. Abt 1858
12
Lucie Ellen Avery
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.6.7.3]
b. 1 Feb 1861 d. 30 Nov 1922 [
=>
]
12
Alice Melissa Avery
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.6.7.4]
b. 9 Nov 1864 d. 28 Nov 1944 [
=>
]
12
Nelson Park Avery
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.6.7.5]
b. 18 Feb 1868 d. 22 Aug 1942 [
=>
]
12
Clarence Morgan Avery
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.6.7.6]
b. 5 Feb 1870 d. 16 Sep 1946
12
Arthur Lewis Avery
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.6.7.7]
b. 24 Jun 1876
11
Lucy Esther Davis
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.6.8]
b. 1 Apr 1834 d. 31 Jan 1907
Nathan Maxson
b. 5 Aug 1830 d. 3 Jul 1858
12
Nathan Elvin Maxson
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.6.8.1]
b. 28 Dec 1856 d. 22 Sep 1885 [
=>
]
Phineas Barber
b. 1816 d. 14 Sep 1899
12
Mary Ellen Barber
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.6.8.2]
b. 1 Oct 1868 d. 29 Jul 1892 [
=>
]
11
Ellen Davis
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.6.9]
b. 31 Jan 1835 d. 27 Nov 1860
Harvey Clark Burdick
b. 12 Aug 1832 d. 19 Sep 1919
12
Ellen May Burdick
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.6.9.1]
b. 13 Oct 1860 d. 8 Mar 1899 [
=>
]
11
Nancy Jane Davis
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.6.10]
b. 8 Dec 1837 d. 20 Nov 1894
Elisha Peckham Clarke
b. 17 Aug 1833 d. 17 Mar 1904
12
Elisha Davis Clarke
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.6.10.1]
b. 17 Oct 1866 d. 18 Oct 1957 [
=>
]
12
Elliott Mason Clarke
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.6.10.2]
b. 17 Oct 1877 d. 31 Oct 1957 [
=>
]
11
Mary Davis
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.6.11]
b. 8 Dec 1839 d. 30 Mar 1931
Henry Gilbert Heath
b. 24 Oct 1827 d. 25 Nov 1895
12
Frank Davis Heath
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.6.11.1]
b. 23 Sep 1865 [
=>
]
+
Nathan A G Wilcox
b. Abt 1839
11
Emily Davis
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.6.12]
b. 20 Nov 1843 d. 31 May 1890
Paul J Burrows
b. 1826 d. 30 Apr 1903
12
Emily Elizabeth Burroughs
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.6.12.1]
b. 3 Oct 1863 d. 11 May 1950 [
=>
]
12
Lillian Burrows
[1.1.4.1.3.2.7.6.2.6.12.2]
b. 27 Jan 1866 d. 1867
9
Jonathan Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.3]
b. 14 Aug 1769 d. Jan 1795
Hannah Stark
b. 1771 d. 30 Sep 1827
10
Daniel Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.3.1]
b. 22 Jun 1794 d. 8 Feb 1835
Christian "Christina" Crouch
b. 23 Oct 1799 d. 5 Jul 1884
11
Daniel Whipple, Jr
[1.1.4.1.3.2.7.6.3.1.1]
b. 7 Oct 1817 d. 10 Nov 1885
Hannah Watrous
b. 3 Sep 1817 d. 16 Aug 1904
12
Julia Ellen Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.3.1.1.1]
b. 26 Jul 1839 d. 9 Feb 1923 [
=>
]
12
Francis Stark Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.3.1.1.2]
b. 13 Nov 1840 d. 13 Oct 1859
12
Henry Watrous Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.3.1.1.3]
b. 27 Jun 1842 d. 16 Sep 1859
12
Daniel Rogers Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.3.1.1.4]
b. 16 Mar 1844 d. 13 Mar 1913 [
=>
]
12
Emily Clarissa Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.3.1.1.5]
b. 23 Sep 1845 d. 23 Mar 1920 [
=>
]
12
Lucy Hannah Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.3.1.1.6]
b. 28 May 1847 d. 12 Oct 1859
12
Chauncey Fremont Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.3.1.1.7]
b. 2 Apr 1856 d. 5 Jun 1933 [
=>
]
12
Jessie Irene Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.3.1.1.8]
b. 12 Jan 1859 d. 11 Apr 1923 [
=>
]
11
Christian Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.3.1.2]
b. 12 Jan 1819 d. 10 Feb 1888
+
Daniel Watrous
b. 20 Feb 1793 d. 18 Apr 1879
11
Mary Ann Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.3.1.3]
b. 1 Jul 1820 d. 6 Mar 1894
John Bolles Whipple
b. 24 Nov 1820 d. 14 Feb 1870
12
Harriet Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.3.1.3.1]
b. 18 May 1843 d. 23 Oct 1897 [
=>
]
12
Mary Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.3.1.3.2]
b. 1845
12
Christina Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.3.1.3.3]
b. 1847 d. 1856
12
Eliza Jane Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.3.1.3.4]
b. 1849 d. 1864
12
Lucy Emma Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.3.1.3.5]
b. 17 Apr 1850 d. 8 Aug 1915 [
=>
]
12
Phebe Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.3.1.3.6]
b. Abt 1851 d. Abt 1852
12
Alden Avery Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.3.1.3.7]
b. Abt 1853 d. 1867
12
Noah Avery Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.3.1.3.8]
b. Abt 1855 d. Abt 1867
12
Hannah Adelia Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.3.1.3.9]
b. 22 Oct 1856 d. 29 Jul 1934 [
=>
]
12
John Franklin Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.3.1.3.10]
b. 14 Jul 1863 d. 5 Mar 1903
11
Henry Horace Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.3.1.4]
b. 31 Oct 1821 d. 2 Mar 1909
Desire Watrous
b. 14 Mar 1820 d. 8 Dec 1882
12
Charles Henry Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.3.1.4.1]
b. 19 Apr 1844 d. 1865
12
William Rogers Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.3.1.4.2]
b. 15 Jun 1845 [
=>
]
12
George A Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.3.1.4.3]
b. Nov 1846 d. 1906 [
=>
]
12
Horace Herbert Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.3.1.4.4]
b. 10 Oct 1848 d. 1921 [
=>
]
12
Lloyd Nelson "Nels" Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.3.1.4.5]
b. 14 Sep 1852 d. Mar 1921 [
=>
]
11
Sally Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.3.1.5]
b. 4 Dec 1823 d. 9 Aug 1900
Dunn McGuire
b. 20 Dec 1822 d. 6 Jan 1894
12
Daniel Whipple McGuire
[1.1.4.1.3.2.7.6.3.1.5.1]
b. 7 Sep 1850 d. 14 Jan 1861
12
Eliza McGuire
[1.1.4.1.3.2.7.6.3.1.5.2]
b. 18 Mar 1852 d. 28 Aug 1932 [
=>
]
12
William McGuire
[1.1.4.1.3.2.7.6.3.1.5.3]
b. 22 Oct 1853 d. 7 Jan 1861
12
Quincy McGuire
[1.1.4.1.3.2.7.6.3.1.5.4]
b. 10 Feb 1855 d. 7 Feb 1922 [
=>
]
12
Mary McGuire
[1.1.4.1.3.2.7.6.3.1.5.5]
b. 14 Mar 1857 d. 24 Aug 1928
12
Daniel Vincent McGuire
[1.1.4.1.3.2.7.6.3.1.5.6]
b. 1 May 1865 d. 6 May 1949 [
=>
]
12
William Victor McGuire
[1.1.4.1.3.2.7.6.3.1.5.7]
b. 1 May 1865 d. 16 Dec 1894
11
Jonathan Crouch Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.3.1.6]
b. 21 Jul 1825 d. 25 Jun 1900
Mary Ann Ecclestone
b. 14 Mar 1831 d. 10 May 1905
12
Eugene Denison Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.3.1.6.1]
b. 1 Mar 1848 d. 12 Mar 1901 [
=>
]
12
Lina Dewey Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.3.1.6.2]
b. 27 Jul 1850 d. 17 Jan 1883 [
=>
]
12
Daniel Edgar Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.3.1.6.3]
b. 25 Dec 1856 d. 26 Dec 1939
12
Edmund Del Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.3.1.6.4]
b. 13 Mar 1861 d. 4 Apr 1861
12
Ambrose Burnside Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.3.1.6.5]
b. 3 Aug 1866 d. 10 Aug 1898
12
Harley Hammond Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.3.1.6.6]
b. 4 May 1870 d. 10 May 1950 [
=>
]
11
Hannah Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.3.1.7]
b. 30 Jun 1827 d. 30 Sep 1827
11
Hannah Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.3.1.8]
b. 1 May 1829 d. 5 May 1856
Charles McGuire
b. 27 Aug 1828 d. 5 Oct 1880
12
Charles Henry McGuire
[1.1.4.1.3.2.7.6.3.1.8.1]
b. 24 Apr 1849
12
Angeline McGuire
[1.1.4.1.3.2.7.6.3.1.8.2]
b. 7 Mar 1851 d. 29 Mar 1851
12
James Elory McGuire
[1.1.4.1.3.2.7.6.3.1.8.3]
b. 3 Apr 1852 d. 26 Mar 1881
12
Elisha Whipple McGuire
[1.1.4.1.3.2.7.6.3.1.8.4]
b. 13 Aug 1854 d. 1 Nov 1940
11
Miriam Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.3.1.9]
b. 26 Jul 1831 d. 10 Jan 1836
11
Content Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.3.1.10]
b. 22 Oct 1833 d. 11 Apr 1838
9
Noah Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.4]
b. 9 Aug 1771
+
Peggy Dunbar
b. 1775
9
Silas Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.5]
b. 25 Jul 1773 d. 1835
Ester Watrous
b. 1772 d. 1853
10
Esther Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.1]
b. 16 Apr 1795 d. 4 Oct 1847
Luther Geer
b. 17 Feb 1793 d. 21 Aug 1871
11
Esther Caroline Geer
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.1.1]
b. 1 Nov 1814 d. Aft 1876
Abram Phenix
b. 25 Dec 1829 d. 27 Sep 1921
12
Mary Jane Phenix
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.1.1.1]
b. Abt 1851
12
Phoebe Ann Phenix
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.1.1.2]
b. 9 Sep 1852 d. 23 Mar 1935 [
=>
]
12
Sarah Melissa Phenix
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.1.1.3]
b. Jun 1856 d. 1920
12
Emma Eliza Phenix
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.1.1.4]
b. 6 Dec 1864 d. 12 Oct 1885 [
=>
]
12
Rosa Maude Phenix
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.1.1.5]
b. 23 Feb 1876 d. 31 Mar 1943 [
=>
]
11
Luther Avery Geer
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.1.2]
b. 15 Mar 1817 d. 27 Jun 1881
Abby Ann Hempstead
b. Abt 1813 d. 20 Jul 1887
12
Luther Avery Geer
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.1.2.1]
b. 17 May 1838 d. 14 Nov 1894 [
=>
]
12
Courtland H Geer
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.1.2.2]
b. 3 Apr 1842 d. 1855
12
John Culberson Geer
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.1.2.3]
b. 17 Oct 1845 [
=>
]
12
Courtland H Geer
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.1.2.4]
b. 28 Nov 1858
11
Solomon Geer
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.1.3]
b. 22 Sep 1819 d. 14 Jul 1892
Nancy Phenix
b. 19 Aug 1824 d. 15 Jan 1899
12
John Owen Geer
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.1.3.1]
b. 1842 d. 9 Sep 1845
12
Lucinda A Geer
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.1.3.2]
b. 1844 d. 1 Dec 1847
12
Martha E Geer
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.1.3.3]
b. 21 Nov 1846 d. 28 Aug 1915 [
=>
]
12
Charles O Geer
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.1.3.4]
b. 1849 d. 1903
12
Abagail Amelia Geer
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.1.3.5]
b. 1850 d. 16 May 1915 [
=>
]
12
Nancy Adelia Geer
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.1.3.6]
b. 1852 d. 14 Mar 1852
12
Mary Elizabeth Geer
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.1.3.7]
b. 8 Jan 1855 d. 14 Oct 1935
12
Adelia Geer
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.1.3.8]
b. 1857
12
Emma E Geer
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.1.3.9]
b. 1857 d. 24 Aug 1863
12
Elmer Harmon Geer
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.1.3.10]
b. 1 Sep 1866 d. 24 Mar 1935 [
=>
]
11
Silas Whipple Geer
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.1.4]
b. 12 Jan 1822 d. 26 Apr 1899
Rebecca Moore
b. 15 Oct 1829 d. 1905
12
Lavina Teresa Geer
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.1.4.1]
b. 7 Apr 1849 d. Bef 1923 [
=>
]
12
Delia Geer
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.1.4.2]
b. Abt 1850
12
Mary Cordelia Geer
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.1.4.3]
b. Jul 1851 d. 1948 [
=>
]
12
Loretta Geer
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.1.4.4]
b. Abt 1854 [
=>
]
12
Barton Geer
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.1.4.5]
b. Jul 1854 [
=>
]
12
Effie Geer
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.1.4.6]
b. Abt 1856
12
Kate Geer
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.1.4.7]
b. Abt 1858
12
Berth Ann Gear
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.1.4.8]
b. Apr 1864 d. 2 Apr 1940 [
=>
]
12
Hattie Geer
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.1.4.9]
b. 1868
11
Lucinda Geer
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.1.5]
b. 12 Oct 1824
Marcus Augustus Stoddard
b. 10 Oct 1817 d. 22 Aug 1876
12
Elisha Stoddard
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.1.5.1]
b. 1844
12
Philemon Frisby Stoddard
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.1.5.2]
b. 9 Feb 1847 d. 21 Mar 1907 [
=>
]
12
Frederick Stoddard
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.1.5.3]
b. 23 Feb 1849 d. 18 Sep 1916 [
=>
]
12
Lewis Kosseuth Stoddard
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.1.5.4]
b. 23 Dec 1851 d. 9 Jul 1926 [
=>
]
12
James Willis Stoddard
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.1.5.5]
b. 15 Jan 1868 d. 30 Aug 1911 [
=>
]
11
Hiram P Geer
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.1.6]
b. 27 Mar 1827
+
Mary Jane Stewart
b. Abt 1831
11
Jacob Geer
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.1.7]
b. 15 Aug 1829 d. Sep 1845
11
Henrietta Geer
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.1.8]
b. 28 Nov 1830
Thomas Dunn
b. Jun 1827 d. Bef 1920
12
William Henry Dunn
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.1.8.1]
b. 12 Aug 1856 d. 12 Jan 1933 [
=>
]
12
Orman Lincoln Dunn
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.1.8.2]
b. 1861 d. 1925 [
=>
]
12
Sidney B Dunn
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.1.8.3]
b. 1866
12
Emma Dunn
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.1.8.4]
b. Dec 1867 [
=>
]
11
Eunice Ophelia Geer
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.1.9]
b. 4 Nov 1838 d. 24 Feb 1917
Leonard Sidney Severance
b. 3 May 1831 d. 1895
12
Ida Derexa Severance
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.1.9.1]
b. 1 Jun 1858 d. 3 Jan 1910 [
=>
]
10
Hope Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.2]
b. 1797
John "John Smith" Mairs
b. 1795 d. 13 May 1883
11
Hope Ardelia Smith
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.2.1]
b. 16 Jun 1826 d. 28 Dec 1896
Horace Waite Tinker
b. 17 Jun 1828 d. 11 Mar 1915
12
Horace Henry Tinker
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.2.1.1]
b. 1853
12
Charles Alphonso Tinker
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.2.1.2]
b. Jun 1855 d. Aft 1905 [
=>
]
12
Esther Ardelia Tinker
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.2.1.3]
b. 14 Oct 1859 d. 25 Dec 1896 [
=>
]
11
Dorothy Carolina Smith
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.2.2]
b. 18 Mar 1828 d. 30 Aug 1917
Captain John Englis Tribble
b. 24 Oct 1820 d. 23 Dec 1893
12
Carrie Carolina Tribble
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.2.2.1]
b. 6 Mar 1850 d. 28 Oct 1864
12
Stella Amelia Tribble
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.2.2.2]
b. 18 Oct 1853 d. 8 Jan 1932
12
Alice Mary Tribble
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.2.2.3]
b. 17 Jan 1857 d. 5 Sep 1934 [
=>
]
12
George Washington Tribble
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.2.2.4]
b. 15 Feb 1859 d. Jan 1937 [
=>
]
11
John Alden Smith
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.2.3]
b. Abt 1829
11
Margaret Smith
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.2.4]
b. Abt 1830
11
Charles Frederick Smith
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.2.5]
b. Abt 1831 d. 30 Aug 1917
11
Elsie Smith
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.2.6]
b. Abt 1832
11
Eliza Smith
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.2.7]
b. Abt 1833
11
John Reynard Smith
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.2.8]
b. Abt 1834
11
Henry Schleiman Smith
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.2.9]
b. 1836 d. 30 Dec 1860
11
Esther Amelia Smith
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.2.10]
b. 1 May 1839 d. 28 Apr 1930
Wheeler Hakes Holmes
b. 6 May 1834 d. 4 Jan 1892
12
Son Holmes
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.2.10.1]
b. 1857
12
Ida Amelia Holmes
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.2.10.2]
b. 5 Nov 1858 d. 22 Mar 1929 [
=>
]
12
Mary Levina Holmes
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.2.10.3]
b. 14 Feb 1861 d. 14 Apr 1918 [
=>
]
12
Charles Elmer Holmes
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.2.10.4]
b. 2 Feb 1864 d. 28 Oct 1926
12
Elsie Maria Babcock Holmes
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.2.10.5]
b. 18 Feb 1870 [
=>
]
10
Content Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.3]
b. 18 Jun 1798 d. 23 Jun 1820
+
Ichabod Davis
b. 9 Aug 1799 d. 17 Sep 1871
10
Ellis Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.4]
b. 1800 d. 1820
10
Hannah Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.5]
b. 1802 d. 10 Jul 1825
Thomas Geer
b. 6 Jan 1801 d. 15 Nov 1866
11
Hannah Cordelia Geer
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.5.1]
b. 11 Aug 1823 d. 10 Sep 1904
William Crouch Whipple
b. 3 Oct 1819 d. 30 Oct 1906
12
Louisa Ann Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.5.1.1]
b. 10 Aug 1841 d. 27 Feb 1902 [
=>
]
12
Phoebe Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.5.1.2]
b. 1843 d. Abt 1854
12
Oliver David Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.5.1.3]
b. 1845 d. 1860
12
Noyce Palmer Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.5.1.4]
b. Abt 1845 d. 1847
12
Carrie Thornton Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.5.1.5]
b. Abt 1847 d. 1847
12
Amos Geer "Owen" Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.5.1.6]
b. Mar 1847 d. 14 May 1872
12
Orin Pierce Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.5.1.7]
b. 18 Apr 1851 d. 13 Sep 1904 [
=>
]
12
Orva Lester Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.5.1.8]
b. 27 Nov 1857 d. 30 Oct 1931 [
=>
]
12
Oscar Yates Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.5.1.9]
b. 7 Jun 1859 d. 20 Dec 1935 [
=>
]
12
Hannah Odella Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.5.1.10]
b. 7 Oct 1863 d. 22 Jul 1929 [
=>
]
12
Lawence Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.5.1.11]
b. 24 Feb 1868 d. 1917 [
=>
]
12
Earnest William Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.5.1.12]
b. 31 Jul 1868 d. 8 Jun 1939 [
=>
]
11
Lucy Ann Geer
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.5.2]
b. 5 Jul 1825 d. 14 Feb 1884
Timothy Whipple
b. 3 Sep 1821 d. 11 Jan 1892
12
Timothy Geer Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.5.2.1]
b. 4 Oct 1843 d. 11 Oct 1844
12
Lucy Anna Geer Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.5.2.2]
b. 6 Oct 1845 d. 6 Nov 1846
12
Daughter Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.5.2.3]
b. 10 Sep 1846
12
Daughter Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.5.2.4]
b. 10 Sep 1848 d. Aft 10 Sep 1848
12
Ida Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.5.2.5]
b. 5 Jan 1849 d. 21 May 1903
12
Phoebe Nellie Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.5.2.6]
b. 6 May 1851 d. 17 Jun 1871 [
=>
]
12
Timothy Thomas Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.5.2.7]
b. 22 Nov 1853 d. 16 Aug 1936
12
Asher Avery Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.5.2.8]
b. 6 Apr 1856 d. 27 Apr 1860
12
Silas Stillman Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.5.2.9]
b. 4 Apr 1859 d. 12 Jan 1935 [
=>
]
12
Annie Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.5.2.10]
b. 11 Feb 1862 d. 12 Aug 1863
12
Samuel Austin Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.5.2.11]
b. 23 Nov 1864 d. 6 Feb 1922 [
=>
]
12
Thomas Geer Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.5.2.12]
b. 8 Dec 1867 d. 29 Jul 1949 [
=>
]
12
Christine Violet Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.5.2.13]
b. 13 Feb 1871 d. 25 Jun 1912 [
=>
]
10
Eunice Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.6]
b. 14 Feb 1805 d. 7 Nov 1829
John Crouch, Jr
b. 19 May 1800 d. Mar 1868
11
Eunice Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.6.1]
b. 7 Nov 1829 d. 9 Feb 1857
11
Silas Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.6.2]
b. 7 Nov 1829 d. 10 Jan 1830
10
Thankful Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.7]
b. 24 Sep 1806 d. 26 May 1894
Thomas Geer
b. 6 Jan 1801 d. 15 Nov 1866
11
Thankful Amela Geer
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.7.1]
b. 18 Feb 1827 d. 11 Dec 1895
Nathan Whipple
b. 20 Jul 1824 d. 6 Mar 1889
12
Julia Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.7.1.1]
b. 2 Sep 1846 d. 17 Apr 1848
12
Nathan Franklin Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.7.1.2]
b. 2 Sep 1847 d. 12 Feb 1908 [
=>
]
12
Julie Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.7.1.3]
b. 8 Aug 1848
12
Lewis DeWayne Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.7.1.4]
b. 27 May 1849 d. 13 Feb 1919 [
=>
]
12
Edith Lillian Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.7.1.5]
b. 1853 d. 17 Nov 1881 [
=>
]
12
Alice Estalina "Lina" Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.7.1.6]
b. 17 Dec 1861 d. 15 Oct 1903
11
Lucy Ann Geer
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.7.2]
b. 18 Feb 1827
11
Eliza Geer
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.7.3]
b. 11 Jun 1833 d. 24 Aug 1902
Reuben Huntley Lester
b. 14 Mar 1831 d. 28 Dec 1904
12
Marietta Lester
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.7.3.1]
b. 17 Jun 1856 d. 20 Oct 1938
12
Olive Huntley Lester
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.7.3.2]
b. Jan 1859 d. Apr 1859
12
Arthur Geer Lester
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.7.3.3]
b. 8 Dec 1864 d. 29 Jun 1910 [
=>
]
12
Reuben Eddie Lester
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.7.3.4]
b. 8 Feb 1875 d. 22 Mar 1933
11
Abby Jane Geer
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.7.4]
b. Abt 1835 d. Abt 1836
11
Emily Jane Geer
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.7.5]
b. 16 Jun 1836 d. 25 Feb 1875
+
Peleg Sisson
b. Abt 1834
Samuel Colburn
b. Abt 1834 d. 1900
12
Carrie Emily Colburn
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.7.5.1]
b. 10 Dec 1866 d. 1877
12
Zella May Colburn
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.7.5.2]
b. 14 Aug 1869 d. 28 May 1954 [
=>
]
12
Lilla Belle Colburn
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.7.5.3]
b. 8 Feb 1872 d. 11 Nov 1923
12
Ida May Colburn
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.7.5.4]
b. Feb 1875 d. 18 Oct 1876
11
Abby Jane Geer
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.7.6]
b. 1838 d. 1839
11
Lucinda Geer
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.7.7]
b. 14 Aug 1840 d. 7 Aug 1903
Frank Horace Bentley
b. 1840 d. Nov 1888
12
Emily Ida Bentley
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.7.7.1]
b. 19 May 1868 d. 13 Aug 1948 [
=>
]
11
Thomas Pierce Geer
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.7.8]
b. 11 Jun 1843 d. 26 Nov 1900
Ella Melinda Fenner
b. 15 Nov 1850 d. 1 Apr 1935
12
Ella Percie Geer
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.7.8.1]
b. 30 May 1873 d. 5 Feb 1942
12
Charles Reginald Geer
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.7.8.2]
b. 16 Nov 1874
12
William Gallup Geer
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.7.8.3]
b. 14 Jun 1878 [
=>
]
12
Edith Emily Geer
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.7.8.4]
b. 29 Feb 1880 d. 29 Mar 1955 [
=>
]
11
Mary Gibson Geer
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.7.9]
b. 21 Jul 1847 d. 17 Dec 1900
Charles Robert Watrous
b. 30 Jul 1836 d. 5 Nov 1913
12
Charles Sherman Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.7.9.1]
b. 28 May 1869 d. 20 Jan 1946 [
=>
]
12
Harold Jabez Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.7.9.2]
b. 6 Feb 1886 d. 21 Mar 1966
11
Abby Jane Geer
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.7.10]
b. Abt 1851
10
Silas Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.8]
b. Abt 1807
10
Abigail Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.9]
b. Apr 1810 d. Dec 1810
10
Timothy Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.10]
b. Feb 1811 d. Apr 1811
10
Alice Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.11]
b. 1814 d. 12 Feb 1891
Lyman D Moffatt
b. 1813
11
Elsie Ann Moffatt
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.11.1]
b. 1836
Joshua Bliven
b. 22 Sep 1833 d. 12 Mar 1893
12
Edna Bliven
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.11.1.1]
b. 11 Dec 1860
12
Lina Bliven
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.11.1.2]
b. 27 Jun 1864 [
=>
]
12
Ray Lyman Bliven
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.11.1.3]
b. Abt 1866
12
Percy Bliven
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.11.1.4]
b. Abt 1867
12
Samuel Bliven
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.11.1.5]
b. Abt 1868
12
Giles Bliven
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.11.1.6]
b. Abt 1870
12
Rose Alice Bliven
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.11.1.7]
b. 15 Jun 1877 [
=>
]
11
Lyman Ray Moffatt
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.11.2]
b. 22 Dec 1837 d. 17 Aug 1885
Ellen F Fuller
b. 26 Jul 1843
12
Fanny Maria Moffitt
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.11.2.1]
b. 15 Mar 1863
12
Emily Thankful Moffatt
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.11.2.2]
b. 25 Nov 1870 d. 7 Oct 1906 [
=>
]
11
Silas Whipple Moffatt
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.11.3]
b. 1841
Sarah "Sally" Watrous
b. 12 Oct 1844
12
Louis Moffatt
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.11.3.1]
b. 1864
11
Anetta Moffatt
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.11.4]
b. 1846
Ori Chapman
b. 1836 d. 7 Apr 1865
12
Ida Lucretia Tracy
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.11.4.1]
b. 6 Jan 1881
12
Arthur Tracy
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.11.4.2]
b. 4 Oct 1888 [
=>
]
Julius A Tracy
b. Abt 1839 d. 2 Mar 1897
12
Edith Tracy
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.11.4.3]
b. 8 Jan 1876 d. 25 Oct 1897 [
=>
]
12
Clarence Julius Tracy
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.11.4.4]
b. 8 Jul 1879 d. 22 Jan 1929 [
=>
]
12
Ida Minette Tracy
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.11.4.5]
b. 6 Jan 1881
12
Herbert Linwood Tracy
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.11.4.6]
b. 14 Dec 1883 [
=>
]
12
Charles A Darwin Tracy
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.11.4.7]
b. 4 Oct 1887
11
Samuel W Moffatt
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.11.5]
b. 1844
+
Emma J Heath
b. 1846
11
John D Moffatt
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.11.6]
b. 25 Sep 1847
+
Flora Eliza Kimball
b. Abt 1850 d. 6 May 1940
11
Eva I Moffatt
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.11.7]
b. 1849 d. 8 Oct 1919
Eugene Kimball
b. 1847 d. Dec 1935
12
Everett Eugene Kimball
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.11.7.1]
b. 12 Feb 1875 d. 9 Feb 1952 [
=>
]
12
Alice Genevieve Kimball
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.11.7.2]
b. 5 Feb 1877 [
=>
]
12
Hannah Miranda Kimball
[1.1.4.1.3.2.7.6.5.11.7.3]
b. 9 Dec 1881 [
=>
]
Sergeant Robert Gowdy
b. Abt 1737
9
Jane Gowdy
[1.1.4.1.3.2.7.6.6]
b. 24 Sep 1779 d. 1861
Amos Watrous
b. 4 Dec 1774 d. 20 Mar 1801
10
Rebecca Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.6.1]
b. 10 Dec 1798 d. 29 Jul 1875
Joseph Watrous
b. 29 Sep 1800 d. 1 Dec 1875
11
Rebecca Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.6.1.1]
b. 22 Nov 1822 d. 16 Dec 1849
11
Joseph Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.6.1.2]
b. 7 Mar 1824 d. 29 Jul 1894
11
Amos Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.6.1.3]
b. 3 Aug 1825 d. 30 Mar 1826
11
Emma Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.6.1.4]
b. 27 Mar 1827 d. 18 May 1901
11
Amos Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.6.1.5]
b. 17 Oct 1828 d. 16 Apr 1885
11
Timothy Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.6.1.6]
b. 26 Sep 1830 d. 26 Mar 1862
11
Robert Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.6.1.7]
b. 13 Mar 1832 d. 31 Oct 1840
11
Leonard Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.6.1.8]
b. 4 Sep 1834 d. 8 Dec 1908
11
William Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.6.1.9]
b. 20 Aug 1836 d. 1 Nov 1840
11
Jane Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.6.1.10]
b. 20 Aug 1838 d. Jul 1911
11
Edwin Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.6.1.11]
b. 17 Oct 1840 d. 28 Dec 1840
10
Amos Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.6.2]
b. 5 Aug 1800 d. 20 Aug 1820
Benajah Davis
b. 1785 d. 1849
10
Laura Ann Davis
[1.1.4.1.3.2.7.6.6.3]
b. 1810 d. 11 Oct 1875
10
Jane Davis
[1.1.4.1.3.2.7.6.6.4]
b. 1812
10
Lucy F Davis
[1.1.4.1.3.2.7.6.6.5]
b. 25 Jul 1815
10
Mary Davis
[1.1.4.1.3.2.7.6.6.6]
b. 1817 d. 1872
10
Benajah Davis
[1.1.4.1.3.2.7.6.6.7]
b. 7 Apr 1820 d. 12 Dec 1904
10
Jeptha Davis
[1.1.4.1.3.2.7.6.6.8]
b. 26 Oct 1822 d. 5 Feb 1867
9
Mary "Polly" Gowdy
[1.1.4.1.3.2.7.6.7]
b. 5 Dec 1782 d. 4 Mar 1871
Jabesh or Jabes Watrous
b. 2 Mar 1774 d. 31 May 1820
10
Mary "Polly" Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.7.1]
b. 12 Jan 1799 d. 3 Jun 1820
Jabez Whipple
b. 15 Apr 1796 d. 14 Dec 1870
11
Jabez Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.7.1.1]
b. 12 Aug 1818 d. 1 May 1875
Harriet Ann Whipple
b. 24 Sep 1821 d. 27 Jul 1869
12
Horace Greely Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.7.1.1.1]
b. 27 Jan 1849 d. 22 Jun 1883
12
Augustus Newcomb Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.7.1.1.2]
b. 12 Jul 1851 d. 5 Jan 1934
12
Ossean Walter Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.7.1.1.3]
b. 15 Nov 1853 d. 23 Aug 1855
12
Jemma Clarence Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.7.1.1.4]
b. 26 May 1856 d. 16 May 1857
12
Eddie Clarence Walter Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.7.1.1.5]
b. 16 Oct 1858 d. 5 Jan 1877
12
Harriet Maria Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.6.7.1.1.6]
b. 1 Aug 1863 d. 9 Jul 1874
10
Hopewell G Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.7.2]
b. 4 Mar 1800 d. 5 Oct 1866
10
Fanny Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.7.3]
b. 4 Feb 1801 d. 3 Jun 1820
10
Jabez Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.7.4]
b. 23 Nov 1803 d. 24 Dec 1900
Phebe Park
b. 16 Mar 1806 d. 22 Sep 1893
11
Jabez Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.7.4.1]
b. 30 Dec 1830 d. 6 Feb 1925
11
Helen M Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.7.4.2]
b. 1 Oct 1833 d. 6 Jan 1896
11
Charles Robert Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.7.4.3]
b. 30 Jul 1836 d. 5 Nov 1913
Mary Gibson Geer
b. 21 Jul 1847 d. 17 Dec 1900
12
Charles Sherman Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.7.4.3.1]
b. 28 May 1869 d. 20 Jan 1946 [
=>
]
12
Harold Jabez Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.7.4.3.2]
b. 6 Feb 1886 d. 21 Mar 1966
11
Henry Stark Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.7.4.4]
b. 25 Apr 1839 d. 14 Jan 1843
11
Phebe Ann Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.7.4.5]
b. 5 Jul 1842 d. 22 Sep 1898
11
Albert G Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.7.4.6]
b. 15 Sep 1844 d. 21 Dec 1918
10
Jane Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.7.5]
b. 15 Sep 1805 d. 25 Apr 1838
10
Robert Gowdy Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.7.6]
b. 13 Sep 1807 d. 2 Feb 1895
10
Bathsheba Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.7.7]
b. 11 Nov 1809 d. 24 Jul 1895
10
Ezra Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.7.8]
b. 9 Jan 1811 d. 27 Mar 1865
10
Ira Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.7.9]
b. 2 Mar 1814 d. 22 Mar 1888
10
Cyrus Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.7.10]
b. 13 Aug 1816 d. 25 May 1820
10
Elias Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.6.7.11]
b. 8 Mar 1819 d. 25 Sep 1889
8
Content Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7]
b. 27 Mar 1743 d. Abt 1830
Timothy Waterhouse
b. 19 Jun 1740 d. 5 Sep 1814
9
Timothy Whipple Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1]
b. 26 May 1765 d. 26 Apr 1820
Hannah Wilcox
b. 25 May 1766 d. 6 Apr 1851
10
William Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.1]
b. Abt 1786 d. 21 Oct 1834
Clarissa Delight Cushman
b. 1791 d. 1822
11
William Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.1.1]
b. 6 Aug 1812 d. 22 Aug 1888
11
Clarissa Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.1.2]
b. 24 Feb 1814 d. 15 Aug 1850
11
Delight Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.1.3]
b. 19 Feb 1816 d. 18 May 1901
Zachariah Crouch
b. 8 Oct 1809 d. 27 Dec 1888
12
Delight Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.1.3.1]
b. 27 Mar 1835 d. 30 Jan 1905 [
=>
]
12
Clarissa Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.1.3.2]
b. 8 Sep 1836 d. 15 Aug 1874
12
Martha Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.1.3.3]
b. 13 Mar 1839 d. 13 May 1885 [
=>
]
12
William Watrous Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.1.3.4]
b. 13 Apr 1841 d. 25 Jun 1876 [
=>
]
12
Julia Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.1.3.5]
b. 20 Sep 1843 d. 20 Aug 1887
12
Jane Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.1.3.6]
b. 23 Sep 1845 d. 8 Jan 1847
12
Rachel Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.1.3.7]
b. 1 Sep 1848 d. 3 Apr 1871
12
Rosilla Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.1.3.8]
b. 18 Dec 1850 d. 14 Jan 1868
12
Emiline Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.1.3.9]
b. 15 Oct 1853 d. 9 Nov 1879
11
Elias Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.1.4]
b. 12 Mar 1818 d. 10 Nov 1891
11
Phebe Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.1.5]
b. 17 Aug 1820 d. 16 Mar 1852
11
John Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.1.6]
b. 9 Oct 1823 d. 9 Feb 1901
11
Julia Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.1.7]
b. 9 Oct 1823
10
Daniel Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.2]
b. 20 Feb 1793 d. 18 Apr 1879
Hephzibah Whipple
b. 18 Jun 1790 d. 6 Oct 1849
11
Daniel Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.2.1]
b. 10 Oct 1814
11
Hepzibah Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.2.2]
b. 27 Feb 1816 d. 29 Aug 1853
+
Abel Tanner
b. 4 Aug 1805 d. 2 Mar 1899
11
Elizabeth Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.2.3]
b. 7 Jun 1817 d. 6 Nov 1888
Samuel Gates Whipple
b. 1 Feb 1817 d. 15 Feb 1904
12
Elizabeth Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.2.3.1]
b. 13 Feb 1839 d. 26 Nov 1844
12
Albert Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.2.3.2]
b. 6 May 1840 d. 4 Mar 1920 [
=>
]
12
Hepzibah Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.2.3.3]
b. 29 Oct 1841 d. 19 Jul 1847
12
Cyrus Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.2.3.4]
b. 22 Mar 1843 d. 10 Jun 1843
12
James Eldon Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.2.3.5]
b. 5 Nov 1847 d. 27 May 1923 [
=>
]
12
Sarah Lavina Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.2.3.6]
b. 8 Dec 1849 d. 7 Nov 1877 [
=>
]
12
Olive Estelle Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.2.3.7]
b. 25 Feb 1852 d. 25 Nov 1918
12
Martha Josephine Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.2.3.8]
b. 2 May 1853 d. 16 Apr 1942 [
=>
]
12
Daniel Joash Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.2.3.9]
b. 17 Jul 1855 d. 24 Feb 1933 [
=>
]
12
Clarissa Isabel Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.2.3.10]
b. 5 Sep 1857 d. 21 Feb 1930 [
=>
]
11
Daniel Watrous, Jr
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.2.4]
b. 16 Apr 1819 d. 29 Apr 1886
Phebe Whipple
b. 8 Aug 1822 d. 28 Dec 1850
12
Emeline Matilda Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.2.4.1]
b. 14 Mar 1847 d. 9 Apr 1853
12
Daniel Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.2.4.2]
b. Abt 1850
+
Content Watrous
b. 19 Oct 1835 d. 27 Nov 1854
Lucy Watrous
b. 28 Mar 1837 d. 23 Oct 1863
12
Silas Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.2.4.3]
b. 5 Mar 1860 d. 1 Feb 1904
12
Daniel E Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.2.4.4]
b. 5 Mar 1860 d. 1 Feb 1904 [
=>
]
+
Rachel Crouch
b. 29 Apr 1824 d. 28 Aug 1897
11
Fanny Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.2.5]
b. Feb 1821 d. 27 Nov 1900
Noah Whipple
b. 21 Jan 1816 d. 23 Sep 1881
12
Edwin Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.2.5.1]
b. 11 Aug 1839 d. 7 Apr 1857
12
Austin Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.2.5.2]
b. 8 Dec 1843 d. 12 May 1863
12
Urban Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.2.5.3]
b. Abt 1845 d. 28 Feb 1899 [
=>
]
12
Warren Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.2.5.4]
b. 10 May 1846 d. 20 Feb 1853
12
Dudley Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.2.5.5]
b. 10 Nov 1847 d. 22 Feb 1853
12
Hiram Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.2.5.6]
b. 20 Sep 1852 d. 9 Jul 1930 [
=>
]
12
Almeda Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.2.5.7]
b. 24 Sep 1854 d. 16 Sep 1856
12
Dudley Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.2.5.8]
b. 5 Dec 1856 d. 9 Dec 1859
11
Mary Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.2.6]
b. 9 Jan 1823 d. 27 May 1846
11
James Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.2.7]
b. 15 Feb 1825 d. 19 Jul 1903
Hannah Watrous
b. 31 Dec 1832 d. 7 Nov 1884
12
Angelina Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.2.7.1]
b. 11 Jul 1852 d. Jun 1888 [
=>
]
12
Mary Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.2.7.2]
b. 8 Nov 1853 d. 13 Oct 1927 [
=>
]
12
Lucy Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.2.7.3]
b. 26 Jul 1855 d. 1938 [
=>
]
12
Lunette Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.2.7.4]
b. 30 May 1857 d. 6 Jan 1921
12
James Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.2.7.5]
b. 26 Sep 1858 d. 7 Aug 1921 [
=>
]
12
Stephen H Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.2.7.6]
b. 17 Jul 1864 d. 26 May 1930 [
=>
]
12
Ernest Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.2.7.7]
b. 10 Sep 1870 d. 24 Mar 1930
11
Nathan Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.2.8]
b. 15 Oct 1827 d. 26 Dec 1827
11
Nathan Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.2.9]
b. 25 Oct 1828 d. 6 Oct 1890
Phebe Ann Mitchell
b. 1833 d. 4 Apr 1895
12
Erastus Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.2.9.1]
b. 5 Oct 1854 d. 17 Mar 1925 [
=>
]
12
Phebe Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.2.9.2]
b. 1 Sep 1856 d. 5 Jan 1945
12
Caroline Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.2.9.3]
b. 7 Jan 1867 d. 17 Apr 1945
12
Austin Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.2.9.4]
b. 21 Jul 1869 d. 29 May 1941
11
Sarah Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.2.10]
b. 26 Feb 1831 d. 11 May 1869
Jabez Crouch, Jr
b. 4 Nov 1833
12
Walter L Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.2.10.1]
b. 5 Jan 1859
12
Lorenzo Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.2.10.2]
b. 11 Feb 1860 d. 26 Aug 1891
12
Sarah Annie Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.2.10.3]
b. 30 Apr 1865 bur. 1 Jan 1904 [
=>
]
+
Christian Whipple
b. 12 Jan 1819 d. 10 Feb 1888
10
Timothy Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.3]
b. Abt 1787 d. 5 Sep 1814
10
Henry Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.4]
b. 14 Oct 1791 d. 26 Jan 1872
Nancy Rogers
b. 2 Oct 1788 d. 10 Feb 1872
11
Mancy Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.4.1]
b. 1813 d. 22 Nov 1891
11
Henry Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.4.2]
b. 1813/1814 d. 3 Mar 1876
11
Olive Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.4.3]
b. 18 Mar 1816 d. 8 Mar 1879
11
Hannah Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.4.4]
b. 3 Sep 1817 d. 16 Aug 1904
Daniel Whipple, Jr
b. 7 Oct 1817 d. 10 Nov 1885
12
Julia Ellen Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.4.4.1]
b. 26 Jul 1839 d. 9 Feb 1923 [
=>
]
12
Francis Stark Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.4.4.2]
b. 13 Nov 1840 d. 13 Oct 1859
12
Henry Watrous Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.4.4.3]
b. 27 Jun 1842 d. 16 Sep 1859
12
Daniel Rogers Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.4.4.4]
b. 16 Mar 1844 d. 13 Mar 1913 [
=>
]
12
Emily Clarissa Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.4.4.5]
b. 23 Sep 1845 d. 23 Mar 1920 [
=>
]
12
Lucy Hannah Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.4.4.6]
b. 28 May 1847 d. 12 Oct 1859
12
Chauncey Fremont Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.4.4.7]
b. 2 Apr 1856 d. 5 Jun 1933 [
=>
]
12
Jessie Irene Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.4.4.8]
b. 12 Jan 1859 d. 11 Apr 1923 [
=>
]
11
Julia Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.4.5]
b. 4 Mar 1819 d. 26 Sep 1844
Samuel Stillman Whipple, III
b. 24 Jun 1820 d. 7 Jun 1848
12
Samuel Stillman Whipple, IV
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.4.5.1]
b. 1843 d. 1 Jun 1864
11
Matilda Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.4.6]
b. 1824
+
Samuel Stillman Whipple, III
b. 24 Jun 1820 d. 7 Jun 1848
11
Emily Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.4.7]
b. 18 Nov 1825 d. 8 Jun 1902
11
Rachel Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.4.8]
b. 1829
11
Lucy Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.4.9]
b. 1831
11
Almira Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.4.10]
b. 1833 d. 24 Apr 1901
11
Desire Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.4.11]
b. 14 Mar 1820 d. 8 Dec 1882
Henry Horace Whipple
b. 31 Oct 1821 d. 2 Mar 1909
12
Charles Henry Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.4.11.1]
b. 19 Apr 1844 d. 1865
12
William Rogers Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.4.11.2]
b. 15 Jun 1845 [
=>
]
12
George A Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.4.11.3]
b. Nov 1846 d. 1906 [
=>
]
12
Horace Herbert Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.4.11.4]
b. 10 Oct 1848 d. 1921 [
=>
]
12
Lloyd Nelson "Nels" Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.4.11.5]
b. 14 Sep 1852 d. Mar 1921 [
=>
]
10
Hannah Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.5]
b. 7 Apr 1795
10
Mary Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.6]
b. 16 Jan 1797
10
Sarah "Sally" Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.7]
b. 16 Nov 1798 d. 13 Sep 1838
Jabez Whipple
b. 15 Apr 1796 d. 14 Dec 1870
11
Timothy Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.7.1]
b. 3 Sep 1821 d. 11 Jan 1892
Lucy Ann Geer
b. 5 Jul 1825 d. 14 Feb 1884
12
Timothy Geer Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.7.1.1]
b. 4 Oct 1843 d. 11 Oct 1844
12
Lucy Anna Geer Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.7.1.2]
b. 6 Oct 1845 d. 6 Nov 1846
12
Daughter Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.7.1.3]
b. 10 Sep 1846
12
Daughter Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.7.1.4]
b. 10 Sep 1848 d. Aft 10 Sep 1848
12
Ida Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.7.1.5]
b. 5 Jan 1849 d. 21 May 1903
12
Phoebe Nellie Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.7.1.6]
b. 6 May 1851 d. 17 Jun 1871 [
=>
]
12
Timothy Thomas Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.7.1.7]
b. 22 Nov 1853 d. 16 Aug 1936
12
Asher Avery Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.7.1.8]
b. 6 Apr 1856 d. 27 Apr 1860
12
Silas Stillman Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.7.1.9]
b. 4 Apr 1859 d. 12 Jan 1935 [
=>
]
12
Annie Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.7.1.10]
b. 11 Feb 1862 d. 12 Aug 1863
12
Samuel Austin Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.7.1.11]
b. 23 Nov 1864 d. 6 Feb 1922 [
=>
]
12
Thomas Geer Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.7.1.12]
b. 8 Dec 1867 d. 29 Jul 1949 [
=>
]
12
Christine Violet Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.7.1.13]
b. 13 Feb 1871 d. 25 Jun 1912 [
=>
]
11
Sarah "Sally" Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.7.2]
b. 28 Nov 1822 d. 11 Jul 1887
Amos Whipple
b. 12 Aug 1818 d. 7 Aug 1894
12
William Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.7.2.1]
b. Abt 1840 d. Abt 1840
12
Sarah Jane Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.7.2.2]
b. 30 May 1842 d. 29 Jul 1887 [
=>
]
12
Pamelia Maria Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.7.2.3]
b. 21 May 1845 d. 29 May 1896 [
=>
]
12
Amos L Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.7.2.4]
b. 4 Aug 1849 d. Bef 1859
11
Nathan Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.7.3]
b. 20 Jul 1824 d. 6 Mar 1889
Thankful Amela Geer
b. 18 Feb 1827 d. 11 Dec 1895
12
Julia Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.7.3.1]
b. 2 Sep 1846 d. 17 Apr 1848
12
Nathan Franklin Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.7.3.2]
b. 2 Sep 1847 d. 12 Feb 1908 [
=>
]
12
Julie Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.7.3.3]
b. 8 Aug 1848
12
Lewis DeWayne Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.7.3.4]
b. 27 May 1849 d. 13 Feb 1919 [
=>
]
12
Edith Lillian Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.7.3.5]
b. 1853 d. 17 Nov 1881 [
=>
]
12
Alice Estalina "Lina" Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.7.3.6]
b. 17 Dec 1861 d. 15 Oct 1903
11
Ira Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.7.4]
b. 9 Apr 1826 d. 29 Apr 1831
11
Mary Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.7.5]
b. 25 Dec 1827 d. 13 Aug 1876
Ichabod Davis, Jr
b. 21 Mar 1824 d. 16 Oct 1907
12
Elisha Davis
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.7.5.1]
b. 3 Dec 1846 d. 8 Mar 1854
12
Elias Davis
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.7.5.2]
b. 12 Mar 1849
12
Helen Thwing Davis
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.7.5.3]
b. 16 Mar 1855 d. 17 May 1856
12
Franklin Herbert Davis
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.7.5.4]
b. 1 Dec 1858 d. 21 Mar 1859
11
Hannah Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.7.6]
b. 27 Dec 1829 d. 19 Dec 1865
Dudley Bailey Chapman
b. 23 Apr 1825 d. 1895
12
Hannah Amelia Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.7.6.1]
b. 6 Feb 1847
12
Alice Burton Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.7.6.2]
b. 19 Mar 1850 d. 15 Jun 1881
12
Eva Louise Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.7.6.3]
b. 10 Apr 1852 d. 8 Feb 1900 [
=>
]
11
Nancy Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.7.7]
b. 16 Jul 1831 d. Jan 1894
+
William Robert Lewers
b. 19 Apr 1829 d. 10 Jul 1865
11
Ira Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.7.8]
b. 14 Jan 1834 d. 9 Apr 1903
Martha Crouch
b. 13 Mar 1839 d. 13 May 1885
12
Frederick Enoch Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.7.8.1]
b. 21 Mar 1861 d. 9 Jun 1939
12
Clara Helen Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.7.8.2]
b. 5 Mar 1864 d. 1947
12
Harry William Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.7.8.3]
b. 5 Dec 1867 d. 9 Sep 1943
12
Rose Emmeline Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.7.8.4]
b. 21 Jan 1870 d. 27 Jul 1962
11
Hepzibah Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.7.9]
b. 27 Dec 1835 d. Abt 1836
11
Silas Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.7.10]
b. 26 Apr 1837 d. Abt Jul 1837
11
Elisha Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.7.11]
b. 23 Jul 1838 d. Abt Sep 1838
10
Joseph Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.8]
b. 29 Sep 1800 d. 1 Dec 1875
Rebecca Watrous
b. 10 Dec 1798 d. 29 Jul 1875
11
Rebecca Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.8.1]
b. 22 Nov 1822 d. 16 Dec 1849
11
Joseph Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.8.2]
b. 7 Mar 1824 d. 29 Jul 1894
11
Amos Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.8.3]
b. 3 Aug 1825 d. 30 Mar 1826
11
Emma Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.8.4]
b. 27 Mar 1827 d. 18 May 1901
11
Amos Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.8.5]
b. 17 Oct 1828 d. 16 Apr 1885
11
Timothy Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.8.6]
b. 26 Sep 1830 d. 26 Mar 1862
11
Robert Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.8.7]
b. 13 Mar 1832 d. 31 Oct 1840
11
Leonard Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.8.8]
b. 4 Sep 1834 d. 8 Dec 1908
11
William Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.8.9]
b. 20 Aug 1836 d. 1 Nov 1840
11
Jane Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.8.10]
b. 20 Aug 1838 d. Jul 1911
11
Edwin Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.8.11]
b. 17 Oct 1840 d. 28 Dec 1840
10
Silas Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.9]
b. 20 Aug 1802 d. 23 Nov 1852
Mary Crouch
b. 30 Apr 1801 d. 11 Sep 1884
11
Mary Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.9.1]
b. Abt 1814 d. 15 Aug 1848
11
Silas Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.9.2]
b. 17 Aug 1824 d. 1870
11
Maria Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.9.3]
b. 14 Nov 1826 d. 1853
11
Nathan Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.9.4]
b. 12 Mar 1828 d. 28 Nov 1828
11
Nathan Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.9.5]
b. 27 Jan 1829
11
Stephen Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.9.6]
b. 11 Sep 1830 d. 10 Jul 1901
11
Charles Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.9.7]
b. 13 Oct 1831 d. 6 Jun 1832
11
Hannah Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.9.8]
b. 31 Dec 1832 d. 7 Nov 1884
James Watrous
b. 15 Feb 1825 d. 19 Jul 1903
12
Angelina Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.9.8.1]
b. 11 Jul 1852 d. Jun 1888 [
=>
]
12
Mary Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.9.8.2]
b. 8 Nov 1853 d. 13 Oct 1927 [
=>
]
12
Lucy Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.9.8.3]
b. 26 Jul 1855 d. 1938 [
=>
]
12
Lunette Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.9.8.4]
b. 30 May 1857 d. 6 Jan 1921
12
James Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.9.8.5]
b. 26 Sep 1858 d. 7 Aug 1921 [
=>
]
12
Stephen H Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.9.8.6]
b. 17 Jul 1864 d. 26 May 1930 [
=>
]
12
Ernest Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.9.8.7]
b. 10 Sep 1870 d. 24 Mar 1930
11
Charles Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.9.9]
b. 11 Jun 1834 d. 4 Jul 1835
11
Content Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.9.10]
b. 19 Oct 1835 d. 27 Nov 1854
+
Daniel Watrous, Jr
b. 16 Apr 1819 d. 29 Apr 1886
11
Lucy Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.9.11]
b. 28 Mar 1837 d. 23 Oct 1863
Daniel Watrous, Jr
b. 16 Apr 1819 d. 29 Apr 1886
12
Silas Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.9.11.1]
b. 5 Mar 1860 d. 1 Feb 1904
12
Daniel E Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.9.11.2]
b. 5 Mar 1860 d. 1 Feb 1904 [
=>
]
11
Fanny Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.9.12]
b. 24 Sep 1838 d. 28 Jun 1897
11
Phebe Ann Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.9.13]
b. 2 Feb 1842 d. 12 Sep 1910
Isaac Stillman Prosser
b. 17 Nov 1830 d. 1 Nov 1895
12
Joseph Watrous Prosser
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.9.13.1]
b. 16 Dec 1865 d. 5 Sep 1934 [
=>
]
12
Mary Eliza Prosser
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.9.13.2]
b. 27 Mar 1867 d. 25 Jan 1937 [
=>
]
12
Isaac Prosser
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.9.13.3]
b. 3 Nov 1868 d. 2 Oct 1870
12
Isaac T Prosser
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.9.13.4]
b. 19 Sep 1870 d. 29 Nov 1938
12
Phebe Jane Prosser
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.9.13.5]
b. 5 May 1872 d. 9 May 1937
12
Nellie M Prosser
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.9.13.6]
b. 16 Jan 1873 d. 20 Oct 1896 [
=>
]
12
Caroline Stillman Prosser
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.9.13.7]
b. 16 Jan 1874
12
Olive Jemima Prosser
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.9.13.8]
b. 27 Oct 1875 d. 27 Nov 1941
12
Lucy Hannah Prosser
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.9.13.9]
b. 25 May 1877 d. 24 Oct 1948
12
Rachel M Prosser
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.9.13.10]
b. 7 Feb 1881 d. 10 Sep 1895
12
Fannie Delight Prosser
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.9.13.11]
b. 30 May 1883 d. 3 Sep 1909
12
Silas Welcome Prosser
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.9.13.12]
b. 9 Sep 1885
11
Son Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.9.14]
b. 8 Jul 1843
11
Sarah "Sally" Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.9.15]
b. 22 Oct 1844
11
William Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.9.16]
b. 30 Mar 1846 d. 24 Sep 1886
11
Charles Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.9.17]
b. 26 Feb 1840 d. Apr 1907
Hannah Crouch
b. 12 Jun 1835 d. 29 Mar 1906
12
Joel Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.9.17.1]
b. 4 Aug 1861 d. 15 Feb 1900 [
=>
]
12
Olive Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.9.17.2]
b. Abt 1867 d. Abt 1877
12
Charles Justin Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.9.17.3]
b. Oct 1868 d. Abt 1878
12
Jacob Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.9.17.4]
b. 6 Mar 1871 d. 18 Aug 1937
12
Hannah Mary Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.9.17.5]
b. 12 Jun 1878 d. 18 Mar 1944
12
Jared E Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.9.17.6]
b. 3 May 1865 d. 5 May 1898 [
=>
]
12
Julia Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.9.17.7]
b. 4 Mar 1863 d. 24 Mar 1906 [
=>
]
10
James Allen Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.10]
b. 7 Jun 1804 d. 28 Dec 1884
10
Hannah Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.11]
b. 26 Mar 1805
10
Nathan Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.12]
b. 19 Jan 1808 d. 1820
10
Content Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.1.13]
b. 11 Dec 1809
9
Zachariah Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.2]
b. 1767 d. 1807
Sarah Adams
b. Abt 1767
10
Zachariah Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.2.1]
b. Abt 1793
10
Lydia Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.2.2]
b. Abt 1796 d. 12 Jan 1870
David Scott
b. 1794 d. 28 Apr 1856
11
John Scott
[1.1.4.1.3.2.7.7.2.2.1]
b. 26 Oct 1821
11
David Scott
[1.1.4.1.3.2.7.7.2.2.2]
b. 27 Feb 1823
11
Zachariah Scott
[1.1.4.1.3.2.7.7.2.2.3]
b. 3 Oct 1824
11
Lydia Scott
[1.1.4.1.3.2.7.7.2.2.4]
b. 26 Jun 1826 d. 1844
11
Eleanor "Ellen" Scott
[1.1.4.1.3.2.7.7.2.2.5]
b. 29 Apr 1829 d. 17 May 1877
John Crouch, Jr
b. 19 May 1800 d. Mar 1868
12
Eleanor "Ellen" Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.2.2.5.1]
b. 24 Sep 1850 d. Oct 1887
12
John Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.2.2.5.2]
b. 10 Jan 1852 d. 20 Nov 1936 [
=>
]
12
Silas B Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.2.2.5.3]
b. 21 Apr 1853 d. 8 Sep 1913 [
=>
]
12
David Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.2.2.5.4]
b. 20 Dec 1854 d. Oct 1934
12
Solomon Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.2.2.5.5]
b. 27 Nov 1856 d. 1892
12
Lydia Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.2.2.5.6]
b. 16 Apr 1858 d. 2 Mar 1946
12
Joel Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.2.2.5.7]
b. 12 Jun 1860 d. 1924
12
Thomas Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.2.2.5.8]
b. 13 Mar 1862 d. 16 Mar 1862
12
Elizabeth Irene Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.2.2.5.9]
b. 19 Nov 1863 d. 7 Dec 1889
11
Thomas Scott
[1.1.4.1.3.2.7.7.2.2.6]
b. 27 Mar 1834
11
Sarah "Sally" Scott
[1.1.4.1.3.2.7.7.2.2.7]
b. 6 Aug 1836
11
Caroline Scott
[1.1.4.1.3.2.7.7.2.2.8]
b. 20 Aug 1839
11
Susanna Scott
[1.1.4.1.3.2.7.7.2.2.9]
b. 18 Apr 1849
10
Content Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.2.3]
b. Abt 1802
10
Sally Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.2.4]
b. Abt 1802
9
Content Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.3]
b. 1769 d. 1853
William Crouch
b. 1766 d. Oct 1840
10
William Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.1]
b. 1792
10
Content Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2]
b. 5 Oct 1794 d. 30 Apr 1835
Noah Whipple
b. 6 Apr 1792 d. 26 Oct 1871
11
Content Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.1]
b. 20 Oct 1814 d. 1875
Ori Chapman
b. 18 Sep 1813 d. 1898
12
Ori Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.1.1]
b. 1836 d. 7 Apr 1865 [
=>
]
12
Nathan Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.1.2]
b. 1838 d. 1857
12
Noah Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.1.3]
b. 1840 d. 26 Apr 1915 [
=>
]
12
Content Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.1.4]
b. 20 Mar 1842 d. 26 Apr 1915 [
=>
]
12
Betsey Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.1.5]
b. Abt 1845 d. 9 Jan 1848
12
Abel T Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.1.6]
b. 30 Mar 1847 d. 15 Dec 1875 [
=>
]
12
Lucy E Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.1.7]
b. 9 Jan 1848
12
Loran C Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.1.8]
b. 23 Apr 1850 [
=>
]
12
William Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.1.9]
b. Abt 1852
11
Noah Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.2]
b. 21 Jan 1816 d. 23 Sep 1881
Fanny Watrous
b. Feb 1821 d. 27 Nov 1900
12
Edwin Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.2.1]
b. 11 Aug 1839 d. 7 Apr 1857
12
Austin Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.2.2]
b. 8 Dec 1843 d. 12 May 1863
12
Urban Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.2.3]
b. Abt 1845 d. 28 Feb 1899 [
=>
]
12
Warren Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.2.4]
b. 10 May 1846 d. 20 Feb 1853
12
Dudley Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.2.5]
b. 10 Nov 1847 d. 22 Feb 1853
12
Hiram Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.2.6]
b. 20 Sep 1852 d. 9 Jul 1930 [
=>
]
12
Almeda Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.2.7]
b. 24 Sep 1854 d. 16 Sep 1856
12
Dudley Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.2.8]
b. 5 Dec 1856 d. 9 Dec 1859
11
Samuel Gates Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.3]
b. 1 Feb 1817 d. 15 Feb 1904
Elizabeth Watrous
b. 7 Jun 1817 d. 6 Nov 1888
12
Elizabeth Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.3.1]
b. 13 Feb 1839 d. 26 Nov 1844
12
Albert Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.3.2]
b. 6 May 1840 d. 4 Mar 1920 [
=>
]
12
Hepzibah Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.3.3]
b. 29 Oct 1841 d. 19 Jul 1847
12
Cyrus Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.3.4]
b. 22 Mar 1843 d. 10 Jun 1843
12
James Eldon Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.3.5]
b. 5 Nov 1847 d. 27 May 1923 [
=>
]
12
Sarah Lavina Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.3.6]
b. 8 Dec 1849 d. 7 Nov 1877 [
=>
]
12
Olive Estelle Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.3.7]
b. 25 Feb 1852 d. 25 Nov 1918
12
Martha Josephine Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.3.8]
b. 2 May 1853 d. 16 Apr 1942 [
=>
]
12
Daniel Joash Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.3.9]
b. 17 Jul 1855 d. 24 Feb 1933 [
=>
]
12
Clarissa Isabel Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.3.10]
b. 5 Sep 1857 d. 21 Feb 1930 [
=>
]
11
Amos Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.4]
b. 12 Aug 1818 d. 7 Aug 1894
Sarah "Sally" Whipple
b. 28 Nov 1822 d. 11 Jul 1887
12
William Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.4.1]
b. Abt 1840 d. Abt 1840
12
Sarah Jane Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.4.2]
b. 30 May 1842 d. 29 Jul 1887 [
=>
]
12
Pamelia Maria Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.4.3]
b. 21 May 1845 d. 29 May 1896 [
=>
]
12
Amos L Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.4.4]
b. 4 Aug 1849 d. Bef 1859
11
William Crouch Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.5]
b. 3 Oct 1819 d. 30 Oct 1906
Hannah Cordelia Geer
b. 11 Aug 1823 d. 10 Sep 1904
12
Louisa Ann Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.5.1]
b. 10 Aug 1841 d. 27 Feb 1902 [
=>
]
12
Phoebe Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.5.2]
b. 1843 d. Abt 1854
12
Oliver David Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.5.3]
b. 1845 d. 1860
12
Noyce Palmer Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.5.4]
b. Abt 1845 d. 1847
12
Carrie Thornton Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.5.5]
b. Abt 1847 d. 1847
12
Amos Geer "Owen" Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.5.6]
b. Mar 1847 d. 14 May 1872
12
Orin Pierce Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.5.7]
b. 18 Apr 1851 d. 13 Sep 1904 [
=>
]
12
Orva Lester Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.5.8]
b. 27 Nov 1857 d. 30 Oct 1931 [
=>
]
12
Oscar Yates Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.5.9]
b. 7 Jun 1859 d. 20 Dec 1935 [
=>
]
12
Hannah Odella Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.5.10]
b. 7 Oct 1863 d. 22 Jul 1929 [
=>
]
12
Lawence Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.5.11]
b. 24 Feb 1868 d. 1917 [
=>
]
12
Earnest William Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.5.12]
b. 31 Jul 1868 d. 8 Jun 1939 [
=>
]
11
John Bolles Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.6]
b. 24 Nov 1820 d. 14 Feb 1870
Mary Ann Whipple
b. 1 Jul 1820 d. 6 Mar 1894
12
Harriet Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.6.1]
b. 18 May 1843 d. 23 Oct 1897 [
=>
]
12
Mary Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.6.2]
b. 1845
12
Christina Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.6.3]
b. 1847 d. 1856
12
Eliza Jane Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.6.4]
b. 1849 d. 1864
12
Lucy Emma Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.6.5]
b. 17 Apr 1850 d. 8 Aug 1915 [
=>
]
12
Phebe Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.6.6]
b. Abt 1851 d. Abt 1852
12
Alden Avery Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.6.7]
b. Abt 1853 d. 1867
12
Noah Avery Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.6.8]
b. Abt 1855 d. Abt 1867
12
Hannah Adelia Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.6.9]
b. 22 Oct 1856 d. 29 Jul 1934 [
=>
]
12
John Franklin Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.6.10]
b. 14 Jul 1863 d. 5 Mar 1903
11
Lucy Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.7]
b. 24 Nov 1820 d. 13 Apr 1894
Jonathan Crouch Whipple
b. 2 Apr 1821 d. 13 Apr 1885
12
Lucy Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.7.1]
b. 24 Feb 1843 d. Nov 1848
12
Content Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.7.2]
b. 27 Jun 1844 d. 25 Oct 1880 [
=>
]
12
Lucy Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.7.3]
b. 4 Dec 1848
12
Zerah Colburn Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.7.4]
b. 1 Sep 1849 d. 12 Sep 1879 [
=>
]
12
Laura Bridgeman Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.7.5]
b. 9 Apr 1852 d. 14 Aug 1915 [
=>
]
12
Walter Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.7.6]
b. 17 Apr 1854 d. 3 Oct 1876
11
Phebe Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.8]
b. 8 Aug 1822 d. 28 Dec 1850
Daniel Watrous, Jr
b. 16 Apr 1819 d. 29 Apr 1886
12
Emeline Matilda Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.8.1]
b. 14 Mar 1847 d. 9 Apr 1853
12
Daniel Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.8.2]
b. Abt 1850
11
Hepzibah Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.9]
b. 16 Dec 1823 d. 27 Dec 1907
Nathan Chapman
b. 27 Mar 1807 d. 28 Nov 1885
12
Nathan Everett Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.9.1]
b. 6 Aug 1847 d. 10 May 1910 [
=>
]
12
Jeannette Whipple Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.9.2]
b. 2 Feb 1852 d. 20 Jan 1894 [
=>
]
12
Mattie Denning Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.9.3]
b. 12 May 1858 d. 20 Mar 1893 [
=>
]
12
Annie Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.9.4]
b. 24 Apr 1867 d. 10 Jan 1940 [
=>
]
12
Bertha Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.9.5]
b. 14 Oct 1868 d. 11 Aug 1938
11
Cyrus Field Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.10]
b. 5 Mar 1825 d. 22 Jun 1911
Delight Whipple
b. 29 Apr 1824 d. 3 Feb 1859
12
Cyrus Evin Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.10.1]
b. 14 Oct 1847 d. 12 Mar 1941 [
=>
]
12
Amos E Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.10.2]
b. 21 Dec 1848 d. 13 Feb 1850
12
Delight Malvina Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.10.3]
b. 21 Sep 1850 d. 15 Oct 1871
12
Hepzibah Ursula Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.10.4]
b. 14 Oct 1852
12
Wylie Anderson Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.10.5]
b. 18 Feb 1855 d. 14 Nov 1922
12
Annette Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.10.6]
b. 3 Feb 1859 d. 11 Dec 1933 [
=>
]
Louise Harriet Rich
b. 29 Mar 1841 d. 13 Dec 1889
12
Estella Louise Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.10.7]
b. 20 Jan 1874 d. 20 Dec 1953 [
=>
]
12
Jennie May Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.10.8]
b. 10 Aug 1875
11
Betsey Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.11]
b. 28 Oct 1826 d. 10 Jan 1902
Timothy Crouch
b. 2 Mar 1826 d. 25 Jan 1874
12
Levi William Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.11.1]
b. 29 May 1848 d. 8 Sep 1920 [
=>
]
12
Timothy A Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.11.2]
b. 2 Jan 1849 d. 16 Sep 1850
12
Frederick Nelson Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.11.3]
b. 6 Aug 1851 d. 17 Mar 1923 [
=>
]
12
Joseph Solomon Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.11.4]
b. 3 Oct 1853 d. 20 May 1946 [
=>
]
12
Courtland M Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.11.5]
b. 10 Jan 1855 d. 14 Oct 1859
12
Franklin P Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.11.6]
b. 8 Jan 1861 d. 24 Mar 1862
12
Edwin Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.11.7]
b. 22 Nov 1863 d. 10 Aug 1864
12
Phebe Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.11.8]
b. 16 Feb 1865 d. 11 May 1868
12
Daniel Elmer Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.11.9]
b. 4 Jan 1868 d. 17 Mar 1955 [
=>
]
12
Samuel Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.11.10]
b. 4 Jan 1868
12
Cynthia Betsey Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.11.11]
b. 16 Aug 1871 d. 20 Jun 1930 [
=>
]
12
Alden Avery Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.11.12]
b. 27 Dec 1856 d. 2 Mar 1932 [
=>
]
+
Ichabod Davis, Jr
b. 21 Mar 1824 d. 16 Oct 1907
11
Joseph Francis Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.12]
b. 13 Jan 1828 d. 6 Sep 1864
11
David Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.13]
b. 8 Jul 1829 d. 29 Jan 1912
Lydia Ann Douglas
b. 12 Mar 1825 d. 20 May 1880
12
Elenora Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.13.1]
b. 28 Feb 1852 d. 11 Aug 1868
12
Gershom Douglas Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.13.2]
b. 7 Jul 1853 d. 28 Jan 1931 [
=>
]
12
Etiole Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.13.3]
b. 6 Apr 1858 d. 28 Jan 1931 [
=>
]
12
Frances M Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.13.4]
b. 18 Feb 1862 d. 12 Aug 1945
12
Bryant Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.13.5]
b. 1864 d. 4 Aug 1868
12
Frederick Merrit Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.13.6]
b. 6 Mar 1869
Jesse Scott
b. 15 Apr 1857 d. 3 Oct 1931
12
Larrabee Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.13.7]
b. 5 Jul 1887
12
Otis Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.13.8]
b. 17 Jul 1890 d. Sep 1982
12
Sidney Herman Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.13.9]
b. 17 Sep 1899 d. Mar 1981
11
Esther Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.14]
b. 16 Sep 1830 d. 14 Aug 1905
Elijah Fitch
b. 15 Jan 1832 d. 13 Feb 1897
12
Ettie Fitch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.14.1]
b. Abt 1851
12
Ella Hepsie Fitch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.14.2]
b. 6 Mar 1854
12
Emmogene Fitch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.14.3]
b. 3 May 1857 d. 11 Nov 1920 [
=>
]
12
Elijah A Fitch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.14.4]
b. 17 Jul 1859 d. 18 Nov 1929 [
=>
]
12
Chester Lewis Fitch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.14.5]
b. 9 Nov 1866
12
Lula Medora Fitch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.14.6]
b. 15 Oct 1868 d. 9 Dec 1917 [
=>
]
11
Zachariah Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.15]
b. 2 Feb 1832 d. 26 Mar 1917
Mary Crouch
b. Abt 1836 d. 18 Nov 1913
12
George Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.15.1]
b. 17 Apr 1857 d. 13 Nov 1919
12
Florence A Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.15.2]
b. 22 Mar 1859 d. 4 Oct 1861
12
Palmer Gates Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.15.3]
b. 1 May 1861 d. 3 Feb 1932
12
Allen Judson Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.15.4]
b. 29 Aug 1863 d. 23 Dec 1941 [
=>
]
12
Laura E Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.15.5]
b. 16 Aug 1865 d. 5 Apr 1872
12
Cynthia Ada Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.15.6]
b. 26 Sep 1868 d. 22 Feb 1907 [
=>
]
12
Julius Zachariah Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.15.7]
b. 28 Aug 1873 d. 18 Oct 1879
11
Rebecca Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.16]
b. 16 Sep 1833 d. 11 Sep 1835
11
Silas Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.2.17]
b. 29 Apr 1835 d. 28 Apr 1836
10
Timothy Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.3]
b. 1797
10
Mary Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.4]
b. 30 Apr 1801 d. 11 Sep 1884
Silas Watrous
b. 20 Aug 1802 d. 23 Nov 1852
11
Mary Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.4.1]
b. Abt 1814 d. 15 Aug 1848
11
Silas Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.4.2]
b. 17 Aug 1824 d. 1870
11
Maria Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.4.3]
b. 14 Nov 1826 d. 1853
11
Nathan Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.4.4]
b. 12 Mar 1828 d. 28 Nov 1828
11
Nathan Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.4.5]
b. 27 Jan 1829
11
Stephen Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.4.6]
b. 11 Sep 1830 d. 10 Jul 1901
11
Charles Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.4.7]
b. 13 Oct 1831 d. 6 Jun 1832
11
Hannah Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.4.8]
b. 31 Dec 1832 d. 7 Nov 1884
James Watrous
b. 15 Feb 1825 d. 19 Jul 1903
12
Angelina Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.4.8.1]
b. 11 Jul 1852 d. Jun 1888 [
=>
]
12
Mary Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.4.8.2]
b. 8 Nov 1853 d. 13 Oct 1927 [
=>
]
12
Lucy Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.4.8.3]
b. 26 Jul 1855 d. 1938 [
=>
]
12
Lunette Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.4.8.4]
b. 30 May 1857 d. 6 Jan 1921
12
James Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.4.8.5]
b. 26 Sep 1858 d. 7 Aug 1921 [
=>
]
12
Stephen H Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.4.8.6]
b. 17 Jul 1864 d. 26 May 1930 [
=>
]
12
Ernest Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.4.8.7]
b. 10 Sep 1870 d. 24 Mar 1930
11
Charles Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.4.9]
b. 11 Jun 1834 d. 4 Jul 1835
11
Content Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.4.10]
b. 19 Oct 1835 d. 27 Nov 1854
+
Daniel Watrous, Jr
b. 16 Apr 1819 d. 29 Apr 1886
11
Lucy Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.4.11]
b. 28 Mar 1837 d. 23 Oct 1863
Daniel Watrous, Jr
b. 16 Apr 1819 d. 29 Apr 1886
12
Silas Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.4.11.1]
b. 5 Mar 1860 d. 1 Feb 1904
12
Daniel E Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.4.11.2]
b. 5 Mar 1860 d. 1 Feb 1904 [
=>
]
11
Fanny Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.4.12]
b. 24 Sep 1838 d. 28 Jun 1897
11
Phebe Ann Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.4.13]
b. 2 Feb 1842 d. 12 Sep 1910
Isaac Stillman Prosser
b. 17 Nov 1830 d. 1 Nov 1895
12
Joseph Watrous Prosser
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.4.13.1]
b. 16 Dec 1865 d. 5 Sep 1934 [
=>
]
12
Mary Eliza Prosser
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.4.13.2]
b. 27 Mar 1867 d. 25 Jan 1937 [
=>
]
12
Isaac Prosser
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.4.13.3]
b. 3 Nov 1868 d. 2 Oct 1870
12
Isaac T Prosser
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.4.13.4]
b. 19 Sep 1870 d. 29 Nov 1938
12
Phebe Jane Prosser
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.4.13.5]
b. 5 May 1872 d. 9 May 1937
12
Nellie M Prosser
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.4.13.6]
b. 16 Jan 1873 d. 20 Oct 1896 [
=>
]
12
Caroline Stillman Prosser
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.4.13.7]
b. 16 Jan 1874
12
Olive Jemima Prosser
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.4.13.8]
b. 27 Oct 1875 d. 27 Nov 1941
12
Lucy Hannah Prosser
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.4.13.9]
b. 25 May 1877 d. 24 Oct 1948
12
Rachel M Prosser
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.4.13.10]
b. 7 Feb 1881 d. 10 Sep 1895
12
Fannie Delight Prosser
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.4.13.11]
b. 30 May 1883 d. 3 Sep 1909
12
Silas Welcome Prosser
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.4.13.12]
b. 9 Sep 1885
11
Son Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.4.14]
b. 8 Jul 1843
11
Sarah "Sally" Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.4.15]
b. 22 Oct 1844
11
William Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.4.16]
b. 30 Mar 1846 d. 24 Sep 1886
11
Charles Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.4.17]
b. 26 Feb 1840 d. Apr 1907
Hannah Crouch
b. 12 Jun 1835 d. 29 Mar 1906
12
Joel Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.4.17.1]
b. 4 Aug 1861 d. 15 Feb 1900 [
=>
]
12
Olive Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.4.17.2]
b. Abt 1867 d. Abt 1877
12
Charles Justin Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.4.17.3]
b. Oct 1868 d. Abt 1878
12
Jacob Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.4.17.4]
b. 6 Mar 1871 d. 18 Aug 1937
12
Hannah Mary Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.4.17.5]
b. 12 Jun 1878 d. 18 Mar 1944
12
Jared E Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.4.17.6]
b. 3 May 1865 d. 5 May 1898 [
=>
]
12
Julia Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.4.17.7]
b. 4 Mar 1863 d. 24 Mar 1906 [
=>
]
10
David Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.5]
b. 7 Jun 1806 d. 25 May 1891
Elizabeth Whipple
b. 2 Nov 1816 d. 2 Sep 1881
11
Elizabeth Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.5.1]
b. 8 Jan 1834 d. 3 Feb 1834
11
Mary Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.5.2]
b. Abt 1836 d. 18 Nov 1913
Zachariah Whipple
b. 2 Feb 1832 d. 26 Mar 1917
12
George Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.5.2.1]
b. 17 Apr 1857 d. 13 Nov 1919
12
Florence A Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.5.2.2]
b. 22 Mar 1859 d. 4 Oct 1861
12
Palmer Gates Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.5.2.3]
b. 1 May 1861 d. 3 Feb 1932
12
Allen Judson Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.5.2.4]
b. 29 Aug 1863 d. 23 Dec 1941 [
=>
]
12
Laura E Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.5.2.5]
b. 16 Aug 1865 d. 5 Apr 1872
12
Cynthia Ada Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.5.2.6]
b. 26 Sep 1868 d. 22 Feb 1907 [
=>
]
12
Julius Zachariah Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.5.2.7]
b. 28 Aug 1873 d. 18 Oct 1879
11
Elizabeth Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.5.3]
b. 9 Jan 1838 d. 1842
11
Allen Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.5.4]
b. 18 Jan 1839 d. 12 Jan 1922
Mary Lewers
b. 14 Dec 1847 d. 25 Sep 1915
12
Mary Alice Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.5.4.1]
b. 2 Sep 1867 d. 14 Dec 1942 [
=>
]
12
Florence Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.5.4.2]
b. 18 Aug 1870 d. 16 Sep 1879
12
Charles Lyntin Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.5.4.3]
b. 10 Nov 1874 d. 18 Apr 1946
12
Joseph Allen Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.5.4.4]
b. 23 Nov 1877 d. 13 Mar 1949 [
=>
]
12
Flora Geneva Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.5.4.5]
b. 13 Mar 1883 [
=>
]
12
Zerah Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.5.4.6]
b. 19 Jul 1888
11
Abbie Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.5.5]
b. 20 Apr 1841 d. 15 Aug 1931
Francis Edwin Merritt
b. 9 Jun 1836 d. 29 Mar 1917
12
Nettie Amba Merritt
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.5.5.1]
b. 9 Sep 1861 d. 5 Jul 1954
12
Ida Champlin Merritt
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.5.5.2]
b. 5 Sep 1863 d. 4 Mar 1922 [
=>
]
12
Bertie Merritt
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.5.5.3]
b. 1865 d. Abt 1868
12
Francis Lawton Merritt
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.5.5.4]
b. 17 Feb 1868 d. 25 Aug 1957 [
=>
]
12
Mary Abbie Merritt
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.5.5.5]
b. 14 Feb 1872 d. 22 Oct 1876
12
Lottie Garfield Merritt
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.5.5.6]
b. 21 May 1881 d. 7 Jun 1953
12
Carrie Bell Merritt
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.5.5.7]
b. 17 Dec 1881 d. 25 Nov 1955 [
=>
]
11
Elizabeth Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.5.6]
b. 28 Apr 1843 d. 13 Aug 1930
Perry Green Palmer
b. Abt 1825 d. Abt 1895
12
Mary Elizabeth Palmer
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.5.6.1]
b. 7 Dec 1863 d. 17 Jul 1949 [
=>
]
12
Charles Perry Palmer
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.5.6.2]
b. 20 Jan 1865 d. 10 Aug 1935
12
Florence Emma Palmer
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.5.6.3]
b. 8 Feb 1867 d. 16 Jul 1903
12
Robert Lewis Palmer
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.5.6.4]
b. 15 Nov 1873 d. 13 Oct 1951
11
David Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.5.7]
b. 17 Mar 1845 d. 1845
11
Enoch Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.5.8]
b. 29 Apr 1846 d. 2 Jun 1905
Lissie Macomber
b. 17 Jul 1854 d. 25 Dec 1927
12
Irvin Edwin Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.5.8.1]
b. 3 Mar 1874 d. 5 Dec 1938 [
=>
]
12
Mary Slack Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.5.8.2]
b. 26 Nov 1876 d. 20 Apr 1942
11
Nathan Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.5.9]
b. 5 Jul 1848 d. 12 Nov 1933
Jane Elizabeth Olin
b. 28 Jan 1850 d. 25 Apr 1914
12
Alice Gertrude Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.5.9.1]
b. 5 Jan 1874 d. 5 May 1946 [
=>
]
12
Jane Elizabeth Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.5.9.2]
b. 6 Apr 1875 d. 23 Apr 1888
+
Lucy Emeline Watrous
b. 28 Jul 1881 d. 1972
11
Lucy Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.5.10]
b. 25 Jun 1850 d. 23 May 1906
Charles Lewers
b. 15 Aug 1849 d. 10 May 1882
12
Phebe Ella Lewers
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.5.10.1]
b. 30 Aug 1875 [
=>
]
12
Joseph William Lewers
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.5.10.2]
b. 26 Nov 1880 d. 16 Mar 1950 [
=>
]
+
Adoniram Judson Spofford
b. 5 Oct 1838 d. Mar 1924
11
Emma Caroline Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.5.11]
b. 21 Jul 1852 d. 23 May 1906
Charles Oscar Akers
b. 14 Aug 1854 d. 22 Jan 1912
12
Cora Emma Akers
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.5.11.1]
b. 16 Dec 1875 [
=>
]
12
Charles Oscar Regins Akers
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.5.11.2]
b. 7 Feb 1878 [
=>
]
12
Ella Marguerite Akers
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.5.11.3]
b. 10 Aug 1879 d. 1964/1969 [
=>
]
12
David Lawrence Akers
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.5.11.4]
b. 6 Nov 1882 d. 30 May 1957 [
=>
]
12
Arthur C Akers
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.5.11.5]
b. 17 Jun 1884 d. 1966
12
Mary Louise Akers
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.5.11.6]
b. 1 Mar 1887
12
Quincy James Akers
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.5.11.7]
b. 30 Jun 1890 d. 1918
11
Alice Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.5.12]
b. 17 May 1854 d. Jul 1854
11
Alice Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.5.13]
b. 2 Jun 1855 d. 4 Dec 1865
10
Jabez Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.6]
b. 7 Oct 1807 d. 7 Jul 1887
Annie Crouch
b. Abt 1805
11
Jabez Crouch, Jr
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.6.1]
b. 4 Nov 1833
Sarah Watrous
b. 26 Feb 1831 d. 11 May 1869
12
Walter L Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.6.1.1]
b. 5 Jan 1859
12
Lorenzo Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.6.1.2]
b. 11 Feb 1860 d. 26 Aug 1891
12
Sarah Annie Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.6.1.3]
b. 30 Apr 1865 bur. 1 Jan 1904 [
=>
]
11
Daniel Elvin Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.6.2]
b. 19 Sep 1834 d. 26 Feb 1865
Desire Amelia Watrous
b. 11 Aug 1836 d. 4 Apr 1912
12
George E Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.6.2.1]
b. 5 Mar 1858 d. 1 May 1858
12
Daniel Elvin Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.6.2.2]
b. 18 Dec 1860
12
Zephaniah William Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.6.2.3]
b. 19 Aug 1862 d. 26 Mar 1886
12
Franklin Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.6.2.4]
b. 3 Jun 1864 d. 22 Nov 1885
12
Amy Ester Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.6.2.5]
b. 23 Jan 1866 d. 23 Jan 1946 [
=>
]
12
Esther Eva Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.6.2.6]
b. 5 Jun 1859 d. 13 Jan 1923 [
=>
]
11
Annie Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.6.3]
b. 1836 d. 1892
11
William Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.6.4]
b. 1836 d. 12 Feb 1918
11
John Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.6.5]
b. 1840
11
Timothy Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.6.6]
b. 1842 d. 9 Apr 1910
11
Miriam Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.6.7]
b. 1844
10
Zachariah Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.7]
b. 8 Oct 1809 d. 27 Dec 1888
Delight Watrous
b. 19 Feb 1816 d. 18 May 1901
11
Delight Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.7.1]
b. 27 Mar 1835 d. 30 Jan 1905
Enoch Whipple
b. 15 Mar 1825 d. 7 Oct 1897
12
Alice Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.7.1.1]
b. 4 Nov 1852 d. 18 Dec 1852
12
Abilier Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.7.1.2]
b. 10 Nov 1853 d. 1 Dec 1853
12
George Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.7.1.3]
b. 9 Mar 1857 d. 25 Apr 1857
12
George Alfred Montgomery
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.7.1.4]
b. Sep 1861 d. 1932 [
=>
]
11
Clarissa Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.7.2]
b. 8 Sep 1836 d. 15 Aug 1874
11
Martha Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.7.3]
b. 13 Mar 1839 d. 13 May 1885
Ira Whipple
b. 14 Jan 1834 d. 9 Apr 1903
12
Frederick Enoch Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.7.3.1]
b. 21 Mar 1861 d. 9 Jun 1939
12
Clara Helen Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.7.3.2]
b. 5 Mar 1864 d. 1947
12
Harry William Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.7.3.3]
b. 5 Dec 1867 d. 9 Sep 1943
12
Rose Emmeline Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.7.3.4]
b. 21 Jan 1870 d. 27 Jul 1962
11
William Watrous Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.7.4]
b. 13 Apr 1841 d. 25 Jun 1876
Edith Lillian Whipple
b. 1853 d. 17 Nov 1881
12
Effie Lillian Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.7.4.1]
b. 8 Jul 1874 d. 8 Dec 1949 [
=>
]
11
Julia Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.7.5]
b. 20 Sep 1843 d. 20 Aug 1887
11
Jane Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.7.6]
b. 23 Sep 1845 d. 8 Jan 1847
11
Rachel Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.7.7]
b. 1 Sep 1848 d. 3 Apr 1871
11
Rosilla Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.7.8]
b. 18 Dec 1850 d. 14 Jan 1868
11
Emiline Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.7.9]
b. 15 Oct 1853 d. 9 Nov 1879
10
Hannah Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.8]
b. 1811 d. 1835
Joel Crouch
b. Abt 1806
11
Hannah Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.8.1]
b. 12 Jun 1835 d. 29 Mar 1906
Charles Watrous
b. 26 Feb 1840 d. Apr 1907
12
Joel Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.8.1.1]
b. 4 Aug 1861 d. 15 Feb 1900 [
=>
]
12
Olive Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.8.1.2]
b. Abt 1867 d. Abt 1877
12
Charles Justin Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.8.1.3]
b. Oct 1868 d. Abt 1878
12
Jacob Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.8.1.4]
b. 6 Mar 1871 d. 18 Aug 1937
12
Hannah Mary Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.8.1.5]
b. 12 Jun 1878 d. 18 Mar 1944
12
Jared E Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.8.1.6]
b. 3 May 1865 d. 5 May 1898 [
=>
]
12
Julia Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.8.1.7]
b. 4 Mar 1863 d. 24 Mar 1906 [
=>
]
10
Esther Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.9]
b. 18 May 1812 d. 27 Oct 1888
10
Christian "Christina" Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10]
b. 23 Oct 1799 d. 5 Jul 1884
Daniel Whipple
b. 22 Jun 1794 d. 8 Feb 1835
11
Daniel Whipple, Jr
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.1]
b. 7 Oct 1817 d. 10 Nov 1885
Hannah Watrous
b. 3 Sep 1817 d. 16 Aug 1904
12
Julia Ellen Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.1.1]
b. 26 Jul 1839 d. 9 Feb 1923 [
=>
]
12
Francis Stark Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.1.2]
b. 13 Nov 1840 d. 13 Oct 1859
12
Henry Watrous Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.1.3]
b. 27 Jun 1842 d. 16 Sep 1859
12
Daniel Rogers Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.1.4]
b. 16 Mar 1844 d. 13 Mar 1913 [
=>
]
12
Emily Clarissa Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.1.5]
b. 23 Sep 1845 d. 23 Mar 1920 [
=>
]
12
Lucy Hannah Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.1.6]
b. 28 May 1847 d. 12 Oct 1859
12
Chauncey Fremont Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.1.7]
b. 2 Apr 1856 d. 5 Jun 1933 [
=>
]
12
Jessie Irene Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.1.8]
b. 12 Jan 1859 d. 11 Apr 1923 [
=>
]
11
Christian Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.2]
b. 12 Jan 1819 d. 10 Feb 1888
+
Daniel Watrous
b. 20 Feb 1793 d. 18 Apr 1879
11
Mary Ann Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.3]
b. 1 Jul 1820 d. 6 Mar 1894
John Bolles Whipple
b. 24 Nov 1820 d. 14 Feb 1870
12
Harriet Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.3.1]
b. 18 May 1843 d. 23 Oct 1897 [
=>
]
12
Mary Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.3.2]
b. 1845
12
Christina Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.3.3]
b. 1847 d. 1856
12
Eliza Jane Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.3.4]
b. 1849 d. 1864
12
Lucy Emma Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.3.5]
b. 17 Apr 1850 d. 8 Aug 1915 [
=>
]
12
Phebe Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.3.6]
b. Abt 1851 d. Abt 1852
12
Alden Avery Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.3.7]
b. Abt 1853 d. 1867
12
Noah Avery Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.3.8]
b. Abt 1855 d. Abt 1867
12
Hannah Adelia Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.3.9]
b. 22 Oct 1856 d. 29 Jul 1934 [
=>
]
12
John Franklin Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.3.10]
b. 14 Jul 1863 d. 5 Mar 1903
11
Henry Horace Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.4]
b. 31 Oct 1821 d. 2 Mar 1909
Desire Watrous
b. 14 Mar 1820 d. 8 Dec 1882
12
Charles Henry Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.4.1]
b. 19 Apr 1844 d. 1865
12
William Rogers Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.4.2]
b. 15 Jun 1845 [
=>
]
12
George A Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.4.3]
b. Nov 1846 d. 1906 [
=>
]
12
Horace Herbert Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.4.4]
b. 10 Oct 1848 d. 1921 [
=>
]
12
Lloyd Nelson "Nels" Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.4.5]
b. 14 Sep 1852 d. Mar 1921 [
=>
]
11
Sally Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.5]
b. 4 Dec 1823 d. 9 Aug 1900
Dunn McGuire
b. 20 Dec 1822 d. 6 Jan 1894
12
Daniel Whipple McGuire
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.5.1]
b. 7 Sep 1850 d. 14 Jan 1861
12
Eliza McGuire
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.5.2]
b. 18 Mar 1852 d. 28 Aug 1932 [
=>
]
12
William McGuire
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.5.3]
b. 22 Oct 1853 d. 7 Jan 1861
12
Quincy McGuire
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.5.4]
b. 10 Feb 1855 d. 7 Feb 1922 [
=>
]
12
Mary McGuire
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.5.5]
b. 14 Mar 1857 d. 24 Aug 1928
12
Daniel Vincent McGuire
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.5.6]
b. 1 May 1865 d. 6 May 1949 [
=>
]
12
William Victor McGuire
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.5.7]
b. 1 May 1865 d. 16 Dec 1894
11
Jonathan Crouch Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.6]
b. 21 Jul 1825 d. 25 Jun 1900
Mary Ann Ecclestone
b. 14 Mar 1831 d. 10 May 1905
12
Eugene Denison Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.6.1]
b. 1 Mar 1848 d. 12 Mar 1901 [
=>
]
12
Lina Dewey Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.6.2]
b. 27 Jul 1850 d. 17 Jan 1883 [
=>
]
12
Daniel Edgar Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.6.3]
b. 25 Dec 1856 d. 26 Dec 1939
12
Edmund Del Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.6.4]
b. 13 Mar 1861 d. 4 Apr 1861
12
Ambrose Burnside Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.6.5]
b. 3 Aug 1866 d. 10 Aug 1898
12
Harley Hammond Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.6.6]
b. 4 May 1870 d. 10 May 1950 [
=>
]
11
Hannah Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.7]
b. 30 Jun 1827 d. 30 Sep 1827
11
Hannah Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.8]
b. 1 May 1829 d. 5 May 1856
Charles McGuire
b. 27 Aug 1828 d. 5 Oct 1880
12
Charles Henry McGuire
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.8.1]
b. 24 Apr 1849
12
Angeline McGuire
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.8.2]
b. 7 Mar 1851 d. 29 Mar 1851
12
James Elory McGuire
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.8.3]
b. 3 Apr 1852 d. 26 Mar 1881
12
Elisha Whipple McGuire
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.8.4]
b. 13 Aug 1854 d. 1 Nov 1940
11
Miriam Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.9]
b. 26 Jul 1831 d. 10 Jan 1836
11
Content Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.10]
b. 22 Oct 1833 d. 11 Apr 1838
Noah Whipple
b. 6 Apr 1792 d. 26 Oct 1871
11
Miriam Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.11]
b. 30 May 1836 d. 3 Jul 1836
11
Rebecca Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.12]
b. 26 Jun 1837 d. 31 Jul 1887
Nelson Hammond
b. 30 Apr 1826 d. 14 Nov 1905
12
Albert Nelson Hammond
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.12.1]
b. 17 Dec 1858 d. 19 Nov 1945 [
=>
]
12
Alice Rebecca Hammond
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.12.2]
b. 10 Jul 1861 d. Feb 1942
12
Flora Evelyn Hammond
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.12.3]
b. 31 May 1875
11
Harriet Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.13]
b. 12 Feb 1840 d. 20 Mar 1843
11
Margaret Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.14]
b. 27 Sep 1842 d. 31 Jan 1914
Josiah Hammond
b. 21 Apr 1821 d. 25 Jan 1895
12
Clara Maria Hammond
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.14.1]
b. 21 Aug 1863 d. 1 Feb 1964 [
=>
]
12
Freddie Josiah Hammond
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.14.2]
b. 1 Dec 1872 d. 15 May 1873
11
Charles Plyman Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.15]
b. 11 Nov 1845 d. 25 Jan 1919
Harriet Ardelia Olin
b. 29 Sep 1847 d. 28 Oct 1892
12
Harriet Ermina Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.15.1]
b. 15 Nov 1866 d. 15 Feb 1905 [
=>
]
12
Charles Nelson Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.15.2]
b. 5 Jan 1869 d. 9 Jan 1876
12
Arthur Clarence Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.15.3]
b. 10 Apr 1872 d. 15 Oct 1936 [
=>
]
12
Oscar Wesley Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.15.4]
b. 7 Jan 1874 d. 15 Jan 1943 [
=>
]
12
Nellie Christina Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.15.5]
b. 1 Dec 1875 d. 27 Jan 1953
12
Addie Isabel Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.15.6]
b. 11 Nov 1879 d. 17 Aug 1945
12
Charles Horton Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.15.7]
b. 30 Oct 1880
12
Mabel Spofford Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.3.10.15.8]
b. 9 May 1885 d. Jul 1969
9
Ester Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.4]
b. 1772 d. 1853
Silas Whipple
b. 25 Jul 1773 d. 1835
10
Esther Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.1]
b. 16 Apr 1795 d. 4 Oct 1847
Luther Geer
b. 17 Feb 1793 d. 21 Aug 1871
11
Esther Caroline Geer
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.1.1]
b. 1 Nov 1814 d. Aft 1876
Abram Phenix
b. 25 Dec 1829 d. 27 Sep 1921
12
Mary Jane Phenix
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.1.1.1]
b. Abt 1851
12
Phoebe Ann Phenix
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.1.1.2]
b. 9 Sep 1852 d. 23 Mar 1935 [
=>
]
12
Sarah Melissa Phenix
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.1.1.3]
b. Jun 1856 d. 1920
12
Emma Eliza Phenix
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.1.1.4]
b. 6 Dec 1864 d. 12 Oct 1885 [
=>
]
12
Rosa Maude Phenix
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.1.1.5]
b. 23 Feb 1876 d. 31 Mar 1943 [
=>
]
11
Luther Avery Geer
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.1.2]
b. 15 Mar 1817 d. 27 Jun 1881
Abby Ann Hempstead
b. Abt 1813 d. 20 Jul 1887
12
Luther Avery Geer
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.1.2.1]
b. 17 May 1838 d. 14 Nov 1894 [
=>
]
12
Courtland H Geer
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.1.2.2]
b. 3 Apr 1842 d. 1855
12
John Culberson Geer
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.1.2.3]
b. 17 Oct 1845 [
=>
]
12
Courtland H Geer
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.1.2.4]
b. 28 Nov 1858
11
Solomon Geer
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.1.3]
b. 22 Sep 1819 d. 14 Jul 1892
Nancy Phenix
b. 19 Aug 1824 d. 15 Jan 1899
12
John Owen Geer
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.1.3.1]
b. 1842 d. 9 Sep 1845
12
Lucinda A Geer
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.1.3.2]
b. 1844 d. 1 Dec 1847
12
Martha E Geer
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.1.3.3]
b. 21 Nov 1846 d. 28 Aug 1915 [
=>
]
12
Charles O Geer
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.1.3.4]
b. 1849 d. 1903
12
Abagail Amelia Geer
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.1.3.5]
b. 1850 d. 16 May 1915 [
=>
]
12
Nancy Adelia Geer
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.1.3.6]
b. 1852 d. 14 Mar 1852
12
Mary Elizabeth Geer
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.1.3.7]
b. 8 Jan 1855 d. 14 Oct 1935
12
Adelia Geer
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.1.3.8]
b. 1857
12
Emma E Geer
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.1.3.9]
b. 1857 d. 24 Aug 1863
12
Elmer Harmon Geer
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.1.3.10]
b. 1 Sep 1866 d. 24 Mar 1935 [
=>
]
11
Silas Whipple Geer
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.1.4]
b. 12 Jan 1822 d. 26 Apr 1899
Rebecca Moore
b. 15 Oct 1829 d. 1905
12
Lavina Teresa Geer
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.1.4.1]
b. 7 Apr 1849 d. Bef 1923 [
=>
]
12
Delia Geer
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.1.4.2]
b. Abt 1850
12
Mary Cordelia Geer
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.1.4.3]
b. Jul 1851 d. 1948 [
=>
]
12
Loretta Geer
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.1.4.4]
b. Abt 1854 [
=>
]
12
Barton Geer
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.1.4.5]
b. Jul 1854 [
=>
]
12
Effie Geer
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.1.4.6]
b. Abt 1856
12
Kate Geer
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.1.4.7]
b. Abt 1858
12
Berth Ann Gear
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.1.4.8]
b. Apr 1864 d. 2 Apr 1940 [
=>
]
12
Hattie Geer
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.1.4.9]
b. 1868
11
Lucinda Geer
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.1.5]
b. 12 Oct 1824
Marcus Augustus Stoddard
b. 10 Oct 1817 d. 22 Aug 1876
12
Elisha Stoddard
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.1.5.1]
b. 1844
12
Philemon Frisby Stoddard
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.1.5.2]
b. 9 Feb 1847 d. 21 Mar 1907 [
=>
]
12
Frederick Stoddard
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.1.5.3]
b. 23 Feb 1849 d. 18 Sep 1916 [
=>
]
12
Lewis Kosseuth Stoddard
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.1.5.4]
b. 23 Dec 1851 d. 9 Jul 1926 [
=>
]
12
James Willis Stoddard
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.1.5.5]
b. 15 Jan 1868 d. 30 Aug 1911 [
=>
]
11
Hiram P Geer
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.1.6]
b. 27 Mar 1827
+
Mary Jane Stewart
b. Abt 1831
11
Jacob Geer
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.1.7]
b. 15 Aug 1829 d. Sep 1845
11
Henrietta Geer
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.1.8]
b. 28 Nov 1830
Thomas Dunn
b. Jun 1827 d. Bef 1920
12
William Henry Dunn
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.1.8.1]
b. 12 Aug 1856 d. 12 Jan 1933 [
=>
]
12
Orman Lincoln Dunn
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.1.8.2]
b. 1861 d. 1925 [
=>
]
12
Sidney B Dunn
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.1.8.3]
b. 1866
12
Emma Dunn
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.1.8.4]
b. Dec 1867 [
=>
]
11
Eunice Ophelia Geer
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.1.9]
b. 4 Nov 1838 d. 24 Feb 1917
Leonard Sidney Severance
b. 3 May 1831 d. 1895
12
Ida Derexa Severance
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.1.9.1]
b. 1 Jun 1858 d. 3 Jan 1910 [
=>
]
10
Hope Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.2]
b. 1797
John "John Smith" Mairs
b. 1795 d. 13 May 1883
11
Hope Ardelia Smith
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.2.1]
b. 16 Jun 1826 d. 28 Dec 1896
Horace Waite Tinker
b. 17 Jun 1828 d. 11 Mar 1915
12
Horace Henry Tinker
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.2.1.1]
b. 1853
12
Charles Alphonso Tinker
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.2.1.2]
b. Jun 1855 d. Aft 1905 [
=>
]
12
Esther Ardelia Tinker
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.2.1.3]
b. 14 Oct 1859 d. 25 Dec 1896 [
=>
]
11
Dorothy Carolina Smith
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.2.2]
b. 18 Mar 1828 d. 30 Aug 1917
Captain John Englis Tribble
b. 24 Oct 1820 d. 23 Dec 1893
12
Carrie Carolina Tribble
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.2.2.1]
b. 6 Mar 1850 d. 28 Oct 1864
12
Stella Amelia Tribble
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.2.2.2]
b. 18 Oct 1853 d. 8 Jan 1932
12
Alice Mary Tribble
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.2.2.3]
b. 17 Jan 1857 d. 5 Sep 1934 [
=>
]
12
George Washington Tribble
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.2.2.4]
b. 15 Feb 1859 d. Jan 1937 [
=>
]
11
John Alden Smith
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.2.3]
b. Abt 1829
11
Margaret Smith
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.2.4]
b. Abt 1830
11
Charles Frederick Smith
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.2.5]
b. Abt 1831 d. 30 Aug 1917
11
Elsie Smith
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.2.6]
b. Abt 1832
11
Eliza Smith
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.2.7]
b. Abt 1833
11
John Reynard Smith
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.2.8]
b. Abt 1834
11
Henry Schleiman Smith
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.2.9]
b. 1836 d. 30 Dec 1860
11
Esther Amelia Smith
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.2.10]
b. 1 May 1839 d. 28 Apr 1930
Wheeler Hakes Holmes
b. 6 May 1834 d. 4 Jan 1892
12
Son Holmes
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.2.10.1]
b. 1857
12
Ida Amelia Holmes
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.2.10.2]
b. 5 Nov 1858 d. 22 Mar 1929 [
=>
]
12
Mary Levina Holmes
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.2.10.3]
b. 14 Feb 1861 d. 14 Apr 1918 [
=>
]
12
Charles Elmer Holmes
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.2.10.4]
b. 2 Feb 1864 d. 28 Oct 1926
12
Elsie Maria Babcock Holmes
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.2.10.5]
b. 18 Feb 1870 [
=>
]
10
Content Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.3]
b. 18 Jun 1798 d. 23 Jun 1820
+
Ichabod Davis
b. 9 Aug 1799 d. 17 Sep 1871
10
Ellis Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.4]
b. 1800 d. 1820
10
Hannah Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.5]
b. 1802 d. 10 Jul 1825
Thomas Geer
b. 6 Jan 1801 d. 15 Nov 1866
11
Hannah Cordelia Geer
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.5.1]
b. 11 Aug 1823 d. 10 Sep 1904
William Crouch Whipple
b. 3 Oct 1819 d. 30 Oct 1906
12
Louisa Ann Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.5.1.1]
b. 10 Aug 1841 d. 27 Feb 1902 [
=>
]
12
Phoebe Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.5.1.2]
b. 1843 d. Abt 1854
12
Oliver David Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.5.1.3]
b. 1845 d. 1860
12
Noyce Palmer Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.5.1.4]
b. Abt 1845 d. 1847
12
Carrie Thornton Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.5.1.5]
b. Abt 1847 d. 1847
12
Amos Geer "Owen" Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.5.1.6]
b. Mar 1847 d. 14 May 1872
12
Orin Pierce Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.5.1.7]
b. 18 Apr 1851 d. 13 Sep 1904 [
=>
]
12
Orva Lester Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.5.1.8]
b. 27 Nov 1857 d. 30 Oct 1931 [
=>
]
12
Oscar Yates Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.5.1.9]
b. 7 Jun 1859 d. 20 Dec 1935 [
=>
]
12
Hannah Odella Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.5.1.10]
b. 7 Oct 1863 d. 22 Jul 1929 [
=>
]
12
Lawence Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.5.1.11]
b. 24 Feb 1868 d. 1917 [
=>
]
12
Earnest William Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.5.1.12]
b. 31 Jul 1868 d. 8 Jun 1939 [
=>
]
11
Lucy Ann Geer
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.5.2]
b. 5 Jul 1825 d. 14 Feb 1884
Timothy Whipple
b. 3 Sep 1821 d. 11 Jan 1892
12
Timothy Geer Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.5.2.1]
b. 4 Oct 1843 d. 11 Oct 1844
12
Lucy Anna Geer Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.5.2.2]
b. 6 Oct 1845 d. 6 Nov 1846
12
Daughter Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.5.2.3]
b. 10 Sep 1846
12
Daughter Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.5.2.4]
b. 10 Sep 1848 d. Aft 10 Sep 1848
12
Ida Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.5.2.5]
b. 5 Jan 1849 d. 21 May 1903
12
Phoebe Nellie Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.5.2.6]
b. 6 May 1851 d. 17 Jun 1871 [
=>
]
12
Timothy Thomas Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.5.2.7]
b. 22 Nov 1853 d. 16 Aug 1936
12
Asher Avery Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.5.2.8]
b. 6 Apr 1856 d. 27 Apr 1860
12
Silas Stillman Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.5.2.9]
b. 4 Apr 1859 d. 12 Jan 1935 [
=>
]
12
Annie Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.5.2.10]
b. 11 Feb 1862 d. 12 Aug 1863
12
Samuel Austin Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.5.2.11]
b. 23 Nov 1864 d. 6 Feb 1922 [
=>
]
12
Thomas Geer Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.5.2.12]
b. 8 Dec 1867 d. 29 Jul 1949 [
=>
]
12
Christine Violet Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.5.2.13]
b. 13 Feb 1871 d. 25 Jun 1912 [
=>
]
10
Eunice Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.6]
b. 14 Feb 1805 d. 7 Nov 1829
John Crouch, Jr
b. 19 May 1800 d. Mar 1868
11
Eunice Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.6.1]
b. 7 Nov 1829 d. 9 Feb 1857
11
Silas Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.6.2]
b. 7 Nov 1829 d. 10 Jan 1830
10
Thankful Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.7]
b. 24 Sep 1806 d. 26 May 1894
Thomas Geer
b. 6 Jan 1801 d. 15 Nov 1866
11
Thankful Amela Geer
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.7.1]
b. 18 Feb 1827 d. 11 Dec 1895
Nathan Whipple
b. 20 Jul 1824 d. 6 Mar 1889
12
Julia Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.7.1.1]
b. 2 Sep 1846 d. 17 Apr 1848
12
Nathan Franklin Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.7.1.2]
b. 2 Sep 1847 d. 12 Feb 1908 [
=>
]
12
Julie Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.7.1.3]
b. 8 Aug 1848
12
Lewis DeWayne Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.7.1.4]
b. 27 May 1849 d. 13 Feb 1919 [
=>
]
12
Edith Lillian Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.7.1.5]
b. 1853 d. 17 Nov 1881 [
=>
]
12
Alice Estalina "Lina" Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.7.1.6]
b. 17 Dec 1861 d. 15 Oct 1903
11
Lucy Ann Geer
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.7.2]
b. 18 Feb 1827
11
Eliza Geer
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.7.3]
b. 11 Jun 1833 d. 24 Aug 1902
Reuben Huntley Lester
b. 14 Mar 1831 d. 28 Dec 1904
12
Marietta Lester
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.7.3.1]
b. 17 Jun 1856 d. 20 Oct 1938
12
Olive Huntley Lester
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.7.3.2]
b. Jan 1859 d. Apr 1859
12
Arthur Geer Lester
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.7.3.3]
b. 8 Dec 1864 d. 29 Jun 1910 [
=>
]
12
Reuben Eddie Lester
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.7.3.4]
b. 8 Feb 1875 d. 22 Mar 1933
11
Abby Jane Geer
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.7.4]
b. Abt 1835 d. Abt 1836
11
Emily Jane Geer
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.7.5]
b. 16 Jun 1836 d. 25 Feb 1875
+
Peleg Sisson
b. Abt 1834
Samuel Colburn
b. Abt 1834 d. 1900
12
Carrie Emily Colburn
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.7.5.1]
b. 10 Dec 1866 d. 1877
12
Zella May Colburn
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.7.5.2]
b. 14 Aug 1869 d. 28 May 1954 [
=>
]
12
Lilla Belle Colburn
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.7.5.3]
b. 8 Feb 1872 d. 11 Nov 1923
12
Ida May Colburn
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.7.5.4]
b. Feb 1875 d. 18 Oct 1876
11
Abby Jane Geer
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.7.6]
b. 1838 d. 1839
11
Lucinda Geer
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.7.7]
b. 14 Aug 1840 d. 7 Aug 1903
Frank Horace Bentley
b. 1840 d. Nov 1888
12
Emily Ida Bentley
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.7.7.1]
b. 19 May 1868 d. 13 Aug 1948 [
=>
]
11
Thomas Pierce Geer
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.7.8]
b. 11 Jun 1843 d. 26 Nov 1900
Ella Melinda Fenner
b. 15 Nov 1850 d. 1 Apr 1935
12
Ella Percie Geer
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.7.8.1]
b. 30 May 1873 d. 5 Feb 1942
12
Charles Reginald Geer
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.7.8.2]
b. 16 Nov 1874
12
William Gallup Geer
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.7.8.3]
b. 14 Jun 1878 [
=>
]
12
Edith Emily Geer
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.7.8.4]
b. 29 Feb 1880 d. 29 Mar 1955 [
=>
]
11
Mary Gibson Geer
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.7.9]
b. 21 Jul 1847 d. 17 Dec 1900
Charles Robert Watrous
b. 30 Jul 1836 d. 5 Nov 1913
12
Charles Sherman Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.7.9.1]
b. 28 May 1869 d. 20 Jan 1946 [
=>
]
12
Harold Jabez Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.7.9.2]
b. 6 Feb 1886 d. 21 Mar 1966
11
Abby Jane Geer
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.7.10]
b. Abt 1851
10
Silas Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.8]
b. Abt 1807
10
Abigail Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.9]
b. Apr 1810 d. Dec 1810
10
Timothy Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.10]
b. Feb 1811 d. Apr 1811
10
Alice Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.11]
b. 1814 d. 12 Feb 1891
Lyman D Moffatt
b. 1813
11
Elsie Ann Moffatt
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.11.1]
b. 1836
Joshua Bliven
b. 22 Sep 1833 d. 12 Mar 1893
12
Edna Bliven
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.11.1.1]
b. 11 Dec 1860
12
Lina Bliven
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.11.1.2]
b. 27 Jun 1864 [
=>
]
12
Ray Lyman Bliven
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.11.1.3]
b. Abt 1866
12
Percy Bliven
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.11.1.4]
b. Abt 1867
12
Samuel Bliven
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.11.1.5]
b. Abt 1868
12
Giles Bliven
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.11.1.6]
b. Abt 1870
12
Rose Alice Bliven
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.11.1.7]
b. 15 Jun 1877 [
=>
]
11
Lyman Ray Moffatt
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.11.2]
b. 22 Dec 1837 d. 17 Aug 1885
Ellen F Fuller
b. 26 Jul 1843
12
Fanny Maria Moffitt
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.11.2.1]
b. 15 Mar 1863
12
Emily Thankful Moffatt
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.11.2.2]
b. 25 Nov 1870 d. 7 Oct 1906 [
=>
]
11
Silas Whipple Moffatt
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.11.3]
b. 1841
Sarah "Sally" Watrous
b. 12 Oct 1844
12
Louis Moffatt
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.11.3.1]
b. 1864
11
Anetta Moffatt
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.11.4]
b. 1846
Ori Chapman
b. 1836 d. 7 Apr 1865
12
Ida Lucretia Tracy
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.11.4.1]
b. 6 Jan 1881
12
Arthur Tracy
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.11.4.2]
b. 4 Oct 1888 [
=>
]
Julius A Tracy
b. Abt 1839 d. 2 Mar 1897
12
Edith Tracy
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.11.4.3]
b. 8 Jan 1876 d. 25 Oct 1897 [
=>
]
12
Clarence Julius Tracy
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.11.4.4]
b. 8 Jul 1879 d. 22 Jan 1929 [
=>
]
12
Ida Minette Tracy
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.11.4.5]
b. 6 Jan 1881
12
Herbert Linwood Tracy
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.11.4.6]
b. 14 Dec 1883 [
=>
]
12
Charles A Darwin Tracy
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.11.4.7]
b. 4 Oct 1887
11
Samuel W Moffatt
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.11.5]
b. 1844
+
Emma J Heath
b. 1846
11
John D Moffatt
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.11.6]
b. 25 Sep 1847
+
Flora Eliza Kimball
b. Abt 1850 d. 6 May 1940
11
Eva I Moffatt
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.11.7]
b. 1849 d. 8 Oct 1919
Eugene Kimball
b. 1847 d. Dec 1935
12
Everett Eugene Kimball
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.11.7.1]
b. 12 Feb 1875 d. 9 Feb 1952 [
=>
]
12
Alice Genevieve Kimball
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.11.7.2]
b. 5 Feb 1877 [
=>
]
12
Hannah Miranda Kimball
[1.1.4.1.3.2.7.7.4.11.7.3]
b. 9 Dec 1881 [
=>
]
9
Jabesh or Jabes Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.5]
b. 2 Mar 1774 d. 31 May 1820
Mary "Polly" Gowdy
b. 5 Dec 1782 d. 4 Mar 1871
10
Mary "Polly" Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.5.1]
b. 12 Jan 1799 d. 3 Jun 1820
Jabez Whipple
b. 15 Apr 1796 d. 14 Dec 1870
11
Jabez Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.5.1.1]
b. 12 Aug 1818 d. 1 May 1875
Harriet Ann Whipple
b. 24 Sep 1821 d. 27 Jul 1869
12
Horace Greely Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.5.1.1.1]
b. 27 Jan 1849 d. 22 Jun 1883
12
Augustus Newcomb Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.5.1.1.2]
b. 12 Jul 1851 d. 5 Jan 1934
12
Ossean Walter Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.5.1.1.3]
b. 15 Nov 1853 d. 23 Aug 1855
12
Jemma Clarence Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.5.1.1.4]
b. 26 May 1856 d. 16 May 1857
12
Eddie Clarence Walter Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.5.1.1.5]
b. 16 Oct 1858 d. 5 Jan 1877
12
Harriet Maria Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.5.1.1.6]
b. 1 Aug 1863 d. 9 Jul 1874
10
Hopewell G Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.5.2]
b. 4 Mar 1800 d. 5 Oct 1866
10
Fanny Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.5.3]
b. 4 Feb 1801 d. 3 Jun 1820
10
Jabez Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.5.4]
b. 23 Nov 1803 d. 24 Dec 1900
Phebe Park
b. 16 Mar 1806 d. 22 Sep 1893
11
Jabez Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.5.4.1]
b. 30 Dec 1830 d. 6 Feb 1925
11
Helen M Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.5.4.2]
b. 1 Oct 1833 d. 6 Jan 1896
11
Charles Robert Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.5.4.3]
b. 30 Jul 1836 d. 5 Nov 1913
Mary Gibson Geer
b. 21 Jul 1847 d. 17 Dec 1900
12
Charles Sherman Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.5.4.3.1]
b. 28 May 1869 d. 20 Jan 1946 [
=>
]
12
Harold Jabez Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.5.4.3.2]
b. 6 Feb 1886 d. 21 Mar 1966
11
Henry Stark Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.5.4.4]
b. 25 Apr 1839 d. 14 Jan 1843
11
Phebe Ann Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.5.4.5]
b. 5 Jul 1842 d. 22 Sep 1898
11
Albert G Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.5.4.6]
b. 15 Sep 1844 d. 21 Dec 1918
10
Jane Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.5.5]
b. 15 Sep 1805 d. 25 Apr 1838
10
Robert Gowdy Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.5.6]
b. 13 Sep 1807 d. 2 Feb 1895
10
Bathsheba Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.5.7]
b. 11 Nov 1809 d. 24 Jul 1895
10
Ezra Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.5.8]
b. 9 Jan 1811 d. 27 Mar 1865
10
Ira Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.5.9]
b. 2 Mar 1814 d. 22 Mar 1888
10
Cyrus Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.5.10]
b. 13 Aug 1816 d. 25 May 1820
10
Elias Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.5.11]
b. 8 Mar 1819 d. 25 Sep 1889
9
Zephaniah Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.6]
b. 1 May 1776 d. Dec 1780
9
John Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.7]
b. 10 Feb 1778 d. 11 Jun 1820
Desire Rogers
b. 20 Jul 1780 d. 12 Mar 1821
10
Desire Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.7.1]
b. Abt 1804 d. 3 Jun 1820
10
Alexander Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.7.2]
b. 1804 d. 1836
Esther Watrous
b. 29 Nov 1809 d. Apr 1903
11
Esther Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.7.2.1]
b. 1833 d. 1868
John Crouch Chapman
b. 18 Jun 1832 d. 22 Jan 1893
12
Augusta Estelle Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.7.2.1.1]
b. 29 May 1853 d. 1 Jul 1901 [
=>
]
12
Martha E Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.7.2.1.2]
b. 1855 d. Abt 1856
12
Elbert A Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.7.2.1.3]
b. 6 Sep 1857 d. 5 Jun 1887
12
Elias A Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.7.2.1.4]
b. 1860 d. Apr 1883
12
Martha Esther Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.7.2.1.5]
b. 22 Feb 1862 d. 24 Mar 1946 [
=>
]
12
Mary Ellen Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.7.2.1.6]
b. 11 May 1864 d. 31 Jul 1950 [
=>
]
11
Desire Amelia Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.7.2.2]
b. 11 Aug 1836 d. 4 Apr 1912
Daniel Elvin Crouch
b. 19 Sep 1834 d. 26 Feb 1865
12
George E Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.7.2.2.1]
b. 5 Mar 1858 d. 1 May 1858
12
Daniel Elvin Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.7.2.2.2]
b. 18 Dec 1860
12
Zephaniah William Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.7.2.2.3]
b. 19 Aug 1862 d. 26 Mar 1886
12
Franklin Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.7.2.2.4]
b. 3 Jun 1864 d. 22 Nov 1885
12
Amy Ester Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.7.2.2.5]
b. 23 Jan 1866 d. 23 Jan 1946 [
=>
]
12
Esther Eva Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.7.2.2.6]
b. 5 Jun 1859 d. 13 Jan 1923 [
=>
]
10
Rachel Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.7.3]
b. 9 May 1806 d. 7 Mar 1826
John Crouch, Jr
b. 19 May 1800 d. Mar 1868
11
John Crouch, III
[1.1.4.1.3.2.7.7.7.3.1]
b. 29 May 1822 d. 29 Sep 1836
11
Rachel Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.7.3.2]
b. 29 Apr 1824 d. 28 Aug 1897
+
Daniel Watrous, Jr
b. 16 Apr 1819 d. 29 Apr 1886
11
Timothy Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.7.3.3]
b. 2 Mar 1826 d. 25 Jan 1874
Betsey Whipple
b. 28 Oct 1826 d. 10 Jan 1902
12
Levi William Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.7.3.3.1]
b. 29 May 1848 d. 8 Sep 1920 [
=>
]
12
Timothy A Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.7.3.3.2]
b. 2 Jan 1849 d. 16 Sep 1850
12
Frederick Nelson Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.7.3.3.3]
b. 6 Aug 1851 d. 17 Mar 1923 [
=>
]
12
Joseph Solomon Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.7.3.3.4]
b. 3 Oct 1853 d. 20 May 1946 [
=>
]
12
Courtland M Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.7.3.3.5]
b. 10 Jan 1855 d. 14 Oct 1859
12
Franklin P Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.7.3.3.6]
b. 8 Jan 1861 d. 24 Mar 1862
12
Edwin Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.7.3.3.7]
b. 22 Nov 1863 d. 10 Aug 1864
12
Phebe Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.7.3.3.8]
b. 16 Feb 1865 d. 11 May 1868
12
Daniel Elmer Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.7.3.3.9]
b. 4 Jan 1868 d. 17 Mar 1955 [
=>
]
12
Samuel Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.7.3.3.10]
b. 4 Jan 1868
12
Cynthia Betsey Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.7.3.3.11]
b. 16 Aug 1871 d. 20 Jun 1930 [
=>
]
12
Alden Avery Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.7.3.3.12]
b. 27 Dec 1856 d. 2 Mar 1932 [
=>
]
10
Joseph Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.7.4]
b. 1806
10
John Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.7.5]
b. 1810
10
Abel Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.7.6]
b. 1812
10
David Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.7.7]
b. 12 Apr 1812 d. 17 Feb 1850
10
Asaph Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.7.8]
b. 1814 d. 31 Jan 1892
10
Content Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.7.9]
b. 1816 d. 27 Apr 1844
9
Elizabeth Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.8]
b. 5 Apr 1780 d. Aft 1862
John Crouch
b. 1777 d. 1869
10
Elizabeth Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.1]
b. 26 Jun 1796 d. 26 Nov 1883
Jonathan Whipple
b. 14 Aug 1794 d. 11 Feb 1875
11
Elizabeth Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.1.1]
b. 2 Nov 1816 d. 2 Sep 1881
David Crouch
b. 7 Jun 1806 d. 25 May 1891
12
Elizabeth Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.1.1.1]
b. 8 Jan 1834 d. 3 Feb 1834
12
Mary Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.1.1.2]
b. Abt 1836 d. 18 Nov 1913 [
=>
]
12
Elizabeth Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.1.1.3]
b. 9 Jan 1838 d. 1842
12
Allen Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.1.1.4]
b. 18 Jan 1839 d. 12 Jan 1922 [
=>
]
12
Abbie Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.1.1.5]
b. 20 Apr 1841 d. 15 Aug 1931 [
=>
]
12
Elizabeth Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.1.1.6]
b. 28 Apr 1843 d. 13 Aug 1930 [
=>
]
12
David Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.1.1.7]
b. 17 Mar 1845 d. 1845
12
Enoch Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.1.1.8]
b. 29 Apr 1846 d. 2 Jun 1905 [
=>
]
12
Nathan Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.1.1.9]
b. 5 Jul 1848 d. 12 Nov 1933 [
=>
]
12
Lucy Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.1.1.10]
b. 25 Jun 1850 d. 23 May 1906 [
=>
]
12
Emma Caroline Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.1.1.11]
b. 21 Jul 1852 d. 23 May 1906 [
=>
]
12
Alice Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.1.1.12]
b. 17 May 1854 d. Jul 1854
12
Alice Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.1.1.13]
b. 2 Jun 1855 d. 4 Dec 1865
11
Mary Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.1.2]
b. 15 Jun 1818 d. 7 Oct 1897
William M Waley
b. Abt 1818
12
Gilbert Gard "Gard" Waley
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.1.2.1]
b. 1 Jun 1853 d. 14 Jan 1918 [
=>
]
11
Jonathan Crouch Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.1.3]
b. 2 Apr 1821 d. 13 Apr 1885
Lucy Whipple
b. 24 Nov 1820 d. 13 Apr 1894
12
Lucy Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.1.3.1]
b. 24 Feb 1843 d. Nov 1848
12
Content Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.1.3.2]
b. 27 Jun 1844 d. 25 Oct 1880 [
=>
]
12
Lucy Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.1.3.3]
b. 4 Dec 1848
12
Zerah Colburn Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.1.3.4]
b. 1 Sep 1849 d. 12 Sep 1879 [
=>
]
12
Laura Bridgeman Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.1.3.5]
b. 9 Apr 1852 d. 14 Aug 1915 [
=>
]
12
Walter Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.1.3.6]
b. 17 Apr 1854 d. 3 Oct 1876
11
Abby Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.1.4]
b. 16 May 1823 d. 3 Jan 1859
+
John Rogers Whipple
b. 18 Dec 1825 d. 23 Sep 1878
11
Enoch Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.1.5]
b. 15 Mar 1825 d. 7 Oct 1897
Delight Crouch
b. 27 Mar 1835 d. 30 Jan 1905
12
Alice Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.1.5.1]
b. 4 Nov 1852 d. 18 Dec 1852
12
Abilier Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.1.5.2]
b. 10 Nov 1853 d. 1 Dec 1853
12
George Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.1.5.3]
b. 9 Mar 1857 d. 25 Apr 1857
12
George Alfred Montgomery
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.1.5.4]
b. Sep 1861 d. 1932 [
=>
]
10
John Crouch, Jr
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.2]
b. 19 May 1800 d. Mar 1868
Eunice Whipple
b. 14 Feb 1805 d. 7 Nov 1829
11
Eunice Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.2.1]
b. 7 Nov 1829 d. 9 Feb 1857
11
Silas Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.2.2]
b. 7 Nov 1829 d. 10 Jan 1830
Rachel Watrous
b. 9 May 1806 d. 7 Mar 1826
11
John Crouch, III
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.2.3]
b. 29 May 1822 d. 29 Sep 1836
11
Rachel Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.2.4]
b. 29 Apr 1824 d. 28 Aug 1897
+
Daniel Watrous, Jr
b. 16 Apr 1819 d. 29 Apr 1886
11
Timothy Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.2.5]
b. 2 Mar 1826 d. 25 Jan 1874
Betsey Whipple
b. 28 Oct 1826 d. 10 Jan 1902
12
Levi William Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.2.5.1]
b. 29 May 1848 d. 8 Sep 1920 [
=>
]
12
Timothy A Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.2.5.2]
b. 2 Jan 1849 d. 16 Sep 1850
12
Frederick Nelson Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.2.5.3]
b. 6 Aug 1851 d. 17 Mar 1923 [
=>
]
12
Joseph Solomon Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.2.5.4]
b. 3 Oct 1853 d. 20 May 1946 [
=>
]
12
Courtland M Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.2.5.5]
b. 10 Jan 1855 d. 14 Oct 1859
12
Franklin P Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.2.5.6]
b. 8 Jan 1861 d. 24 Mar 1862
12
Edwin Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.2.5.7]
b. 22 Nov 1863 d. 10 Aug 1864
12
Phebe Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.2.5.8]
b. 16 Feb 1865 d. 11 May 1868
12
Daniel Elmer Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.2.5.9]
b. 4 Jan 1868 d. 17 Mar 1955 [
=>
]
12
Samuel Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.2.5.10]
b. 4 Jan 1868
12
Cynthia Betsey Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.2.5.11]
b. 16 Aug 1871 d. 20 Jun 1930 [
=>
]
12
Alden Avery Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.2.5.12]
b. 27 Dec 1856 d. 2 Mar 1932 [
=>
]
Eleanor "Ellen" Scott
b. 29 Apr 1829 d. 17 May 1877
11
Eleanor "Ellen" Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.2.6]
b. 24 Sep 1850 d. Oct 1887
11
John Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.2.7]
b. 10 Jan 1852 d. 20 Nov 1936
Angelina Watrous
b. 11 Jul 1852 d. Jun 1888
12
Rosaline "Rosa" Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.2.7.1]
b. Jan 1877 d. 1880
12
Hannah Lucy Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.2.7.2]
b. 29 Jul 1877 d. 12 Dec 1942
12
Arthur Henry Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.2.7.3]
b. 2 Aug 1879 d. 21 Nov 1948 [
=>
]
12
Elmer Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.2.7.4]
b. Oct 1880 d. 1882
12
Celia Mabel Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.2.7.5]
b. 25 Oct 1883
12
Clara Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.2.7.6]
b. Oct 1887
12
Angeline Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.2.7.7]
b. 3 Jun 1886 d. 26 Jun 1964 [
=>
]
11
Silas B Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.2.8]
b. 21 Apr 1853 d. 8 Sep 1913
Julia Abbey Peckham
b. 30 Aug 1854 d. 1 Apr 1914
12
Silas Edward Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.2.8.1]
b. 7 May 1876 d. 26 Dec 1881
12
Stephen Elsworth Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.2.8.2]
b. 18 Jan 1879 d. 11 Oct 1938
12
Julia Almira Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.2.8.3]
b. 4 Oct 1881 d. 4 Sep 1907
12
Herbert Gene Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.2.8.4]
b. 9 Aug 1883 d. 11 Oct 1940 [
=>
]
12
Alfton Fuller Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.2.8.5]
b. 20 Nov 1885 d. 18 Feb 1952
12
Percy Tennyson Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.2.8.6]
b. 4 Jun 1886
12
Louise Ellen Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.2.8.7]
b. 22 Jun 1892 d. 4 Jun 1957
12
John Richard Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.2.8.8]
b. 14 Jun 1900 d. 7 Mar 1919
11
David Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.2.9]
b. 20 Dec 1854 d. Oct 1934
11
Solomon Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.2.10]
b. 27 Nov 1856 d. 1892
11
Lydia Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.2.11]
b. 16 Apr 1858 d. 2 Mar 1946
11
Joel Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.2.12]
b. 12 Jun 1860 d. 1924
11
Thomas Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.2.13]
b. 13 Mar 1862 d. 16 Mar 1862
11
Elizabeth Irene Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.2.14]
b. 19 Nov 1863 d. 7 Dec 1889
10
Mary Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.3]
b. 1802 d. 12 Jan 1891
10
Abiah Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.4]
b. 18 Sep 1804 d. 21 Nov 1871
Samuel Chapman
b. 30 Jan 1806 d. 16 Oct 1844
11
Elizabeth Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.4.1]
b. 21 Jul 1829 d. Dec 1907
George H Olin
b. Jan 1843 d. 8 Jun 1904
12
George R Olin
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.4.1.1]
b. 19 Jan 1867 d. 1867
12
Samuel Riley Olin
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.4.1.2]
b. 3 Jun 1868 d. 18 Feb 1956 [
=>
]
11
John Crouch Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.4.2]
b. 18 Jun 1832 d. 22 Jan 1893
Esther Watrous
b. 1833 d. 1868
12
Augusta Estelle Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.4.2.1]
b. 29 May 1853 d. 1 Jul 1901 [
=>
]
12
Martha E Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.4.2.2]
b. 1855 d. Abt 1856
12
Elbert A Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.4.2.3]
b. 6 Sep 1857 d. 5 Jun 1887
12
Elias A Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.4.2.4]
b. 1860 d. Apr 1883
12
Martha Esther Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.4.2.5]
b. 22 Feb 1862 d. 24 Mar 1946 [
=>
]
12
Mary Ellen Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.4.2.6]
b. 11 May 1864 d. 31 Jul 1950 [
=>
]
11
Daniel Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.4.3]
b. 18 Jun 1832 d. 5 Nov 1879
Ann Maira Olin
b. 25 Nov 1844 d. 16 May 1927
12
Addie Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.4.3.1]
b. 6 Feb 1863 d. 14 Jan 1949 [
=>
]
12
Byron Harvey Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.4.3.2]
b. 3 Mar 1867 d. 22 Sep 1944 [
=>
]
11
Miriam Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.4.4]
b. 8 Jan 1833 d. 10 Oct 1904
John Willette Watson
b. 1 Jan 1833 d. 7 Nov 1917
12
William Riley Watson
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.4.4.1]
b. 17 Jul 1860 d. 3 Jul 1897 [
=>
]
12
John Lewis Watson
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.4.4.2]
b. 23 Nov 1861 d. 1895
12
Charles Henry Watson
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.4.4.3]
b. 6 Jun 1865 d. 29 Jun 1934
12
Jennie May Watson
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.4.4.4]
b. 3 Aug 1866 d. Nov 1940
12
George Willette Watson
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.4.4.5]
b. 7 May 1868 d. Jul 1950
12
Augusta Ella Watson
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.4.4.6]
b. 6 Oct 1869 d. 1940 [
=>
]
11
Abiah Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.4.5]
b. 23 Sep 1834 d. 2 Nov 1911
Josiah Fuller Phillips
b. 28 Feb 1826 d. 26 Nov 1896
12
Mary Ann Adams Phillips
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.4.5.1]
b. 17 Jun 1853 d. 10 May 1915 [
=>
]
12
Emmanual Walter Phillips
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.4.5.2]
b. 20 Feb 1857 d. 27 Apr 1935 [
=>
]
12
Lucy Williams Phillips
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.4.5.3]
b. 8 Jan 1859 d. 28 Jun 1930 [
=>
]
12
Wendell Phillips
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.4.5.4]
b. 20 Nov 1861 d. 1 Sep 1883
12
Emeline Amelia Phillips
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.4.5.5]
b. 12 Aug 1864 d. 29 Jun 1894
12
George Elmer Phillips
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.4.5.6]
b. 16 Jul 1866 d. 14 Nov 1929 [
=>
]
12
Fennelia Nettie Phillips
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.4.5.7]
b. 8 Oct 1868 d. 5 Dec 1956
12
Elizabeth Lillian Anna "Lily" Phillips
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.4.5.8]
b. 1 May 1870 d. 3 Oct 1930 [
=>
]
12
Arthur Bernise Phillips
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.4.5.9]
b. 7 Feb 1873 d. 26 Sep 1961 [
=>
]
11
Mary Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.4.6]
b. 20 Jul 1836 d. 5 Nov 1879
11
Samuel Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.4.7]
b. 27 Jul 1838 d. 8 Apr 1862
11
Lucy Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.4.8]
b. 27 Mar 1842 d. 7 Aug 1842
11
Elias Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.4.9]
b. 17 Aug 1843 d. 10 Feb 1844
10
Annie Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.5]
b. Abt 1805
Jabez Crouch
b. 7 Oct 1807 d. 7 Jul 1887
11
Jabez Crouch, Jr
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.5.1]
b. 4 Nov 1833
Sarah Watrous
b. 26 Feb 1831 d. 11 May 1869
12
Walter L Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.5.1.1]
b. 5 Jan 1859
12
Lorenzo Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.5.1.2]
b. 11 Feb 1860 d. 26 Aug 1891
12
Sarah Annie Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.5.1.3]
b. 30 Apr 1865 bur. 1 Jan 1904 [
=>
]
11
Daniel Elvin Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.5.2]
b. 19 Sep 1834 d. 26 Feb 1865
Desire Amelia Watrous
b. 11 Aug 1836 d. 4 Apr 1912
12
George E Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.5.2.1]
b. 5 Mar 1858 d. 1 May 1858
12
Daniel Elvin Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.5.2.2]
b. 18 Dec 1860
12
Zephaniah William Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.5.2.3]
b. 19 Aug 1862 d. 26 Mar 1886
12
Franklin Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.5.2.4]
b. 3 Jun 1864 d. 22 Nov 1885
12
Amy Ester Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.5.2.5]
b. 23 Jan 1866 d. 23 Jan 1946 [
=>
]
12
Esther Eva Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.5.2.6]
b. 5 Jun 1859 d. 13 Jan 1923 [
=>
]
11
Annie Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.5.3]
b. 1836 d. 1892
11
William Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.5.4]
b. 1836 d. 12 Feb 1918
11
John Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.5.5]
b. 1840
11
Timothy Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.5.6]
b. 1842 d. 9 Apr 1910
11
Miriam Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.5.7]
b. 1844
10
Joel Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.6]
b. Abt 1806
Hannah Crouch
b. 1811 d. 1835
11
Hannah Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.6.1]
b. 12 Jun 1835 d. 29 Mar 1906
Charles Watrous
b. 26 Feb 1840 d. Apr 1907
12
Joel Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.6.1.1]
b. 4 Aug 1861 d. 15 Feb 1900 [
=>
]
12
Olive Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.6.1.2]
b. Abt 1867 d. Abt 1877
12
Charles Justin Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.6.1.3]
b. Oct 1868 d. Abt 1878
12
Jacob Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.6.1.4]
b. 6 Mar 1871 d. 18 Aug 1937
12
Hannah Mary Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.6.1.5]
b. 12 Jun 1878 d. 18 Mar 1944
12
Jared E Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.6.1.6]
b. 3 May 1865 d. 5 May 1898 [
=>
]
12
Julia Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.6.1.7]
b. 4 Mar 1863 d. 24 Mar 1906 [
=>
]
10
Solomon Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.7]
b. Abt 1809
10
Daniel Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.8]
b. Abt 1814
10
Christian Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.9]
b. 1824
Paul Whipple
b. 23 Dec 1822 d. 1868
11
Mary Christian Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.9.1]
b. 1846 d. 11 Aug 1876
William L Lawrell
b. 1851 d. 6 Jul 1922
12
Frank R Lawrell
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.9.1.1]
b. 17 Feb 1875 d. 26 Mar 1876
11
Paul Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.9.2]
b. 10 Aug 1847 d. 1890
11
Hannah Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.9.3]
b. 1848 d. 8 Mar 1882
11
Miriam Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.9.4]
b. 2 May 1849
11
Harvey Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.9.5]
b. Abt 1852 d. 1 Aug 1894
+
Mary Frances West
b. Abt 1855
11
Ida Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.9.6]
b. 1856 d. 1887
11
Allen Gates Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.9.7]
b. 3 Sep 1857 d. 15 Jun 1936
Lucy Watrous
b. 26 Jul 1855 d. 1938
12
Paul A Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.9.7.1]
b. May 1895 d. 29 Jan 1957
11
Harriet Elizabeth Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.7.8.9.8]
b. Abt 1859
9
Abiah Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.9]
b. 1 May 1782 d. 1820
Samuel Chapman
b. Abt 1781 d. 20 Apr 1868
10
Samuel Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.1]
b. 30 Jan 1806 d. 16 Oct 1844
Abiah Crouch
b. 18 Sep 1804 d. 21 Nov 1871
11
Elizabeth Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.1.1]
b. 21 Jul 1829 d. Dec 1907
George H Olin
b. Jan 1843 d. 8 Jun 1904
12
George R Olin
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.1.1.1]
b. 19 Jan 1867 d. 1867
12
Samuel Riley Olin
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.1.1.2]
b. 3 Jun 1868 d. 18 Feb 1956 [
=>
]
11
John Crouch Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.1.2]
b. 18 Jun 1832 d. 22 Jan 1893
Esther Watrous
b. 1833 d. 1868
12
Augusta Estelle Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.1.2.1]
b. 29 May 1853 d. 1 Jul 1901 [
=>
]
12
Martha E Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.1.2.2]
b. 1855 d. Abt 1856
12
Elbert A Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.1.2.3]
b. 6 Sep 1857 d. 5 Jun 1887
12
Elias A Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.1.2.4]
b. 1860 d. Apr 1883
12
Martha Esther Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.1.2.5]
b. 22 Feb 1862 d. 24 Mar 1946 [
=>
]
12
Mary Ellen Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.1.2.6]
b. 11 May 1864 d. 31 Jul 1950 [
=>
]
11
Daniel Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.1.3]
b. 18 Jun 1832 d. 5 Nov 1879
Ann Maira Olin
b. 25 Nov 1844 d. 16 May 1927
12
Addie Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.1.3.1]
b. 6 Feb 1863 d. 14 Jan 1949 [
=>
]
12
Byron Harvey Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.1.3.2]
b. 3 Mar 1867 d. 22 Sep 1944 [
=>
]
11
Miriam Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.1.4]
b. 8 Jan 1833 d. 10 Oct 1904
John Willette Watson
b. 1 Jan 1833 d. 7 Nov 1917
12
William Riley Watson
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.1.4.1]
b. 17 Jul 1860 d. 3 Jul 1897 [
=>
]
12
John Lewis Watson
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.1.4.2]
b. 23 Nov 1861 d. 1895
12
Charles Henry Watson
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.1.4.3]
b. 6 Jun 1865 d. 29 Jun 1934
12
Jennie May Watson
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.1.4.4]
b. 3 Aug 1866 d. Nov 1940
12
George Willette Watson
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.1.4.5]
b. 7 May 1868 d. Jul 1950
12
Augusta Ella Watson
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.1.4.6]
b. 6 Oct 1869 d. 1940 [
=>
]
11
Abiah Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.1.5]
b. 23 Sep 1834 d. 2 Nov 1911
Josiah Fuller Phillips
b. 28 Feb 1826 d. 26 Nov 1896
12
Mary Ann Adams Phillips
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.1.5.1]
b. 17 Jun 1853 d. 10 May 1915 [
=>
]
12
Emmanual Walter Phillips
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.1.5.2]
b. 20 Feb 1857 d. 27 Apr 1935 [
=>
]
12
Lucy Williams Phillips
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.1.5.3]
b. 8 Jan 1859 d. 28 Jun 1930 [
=>
]
12
Wendell Phillips
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.1.5.4]
b. 20 Nov 1861 d. 1 Sep 1883
12
Emeline Amelia Phillips
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.1.5.5]
b. 12 Aug 1864 d. 29 Jun 1894
12
George Elmer Phillips
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.1.5.6]
b. 16 Jul 1866 d. 14 Nov 1929 [
=>
]
12
Fennelia Nettie Phillips
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.1.5.7]
b. 8 Oct 1868 d. 5 Dec 1956
12
Elizabeth Lillian Anna "Lily" Phillips
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.1.5.8]
b. 1 May 1870 d. 3 Oct 1930 [
=>
]
12
Arthur Bernise Phillips
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.1.5.9]
b. 7 Feb 1873 d. 26 Sep 1961 [
=>
]
11
Mary Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.1.6]
b. 20 Jul 1836 d. 5 Nov 1879
11
Samuel Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.1.7]
b. 27 Jul 1838 d. 8 Apr 1862
11
Lucy Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.1.8]
b. 27 Mar 1842 d. 7 Aug 1842
11
Elias Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.1.9]
b. 17 Aug 1843 d. 10 Feb 1844
10
Nathan Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.2]
b. 27 Mar 1807 d. 28 Nov 1885
Hepzibah Whipple
b. 16 Dec 1823 d. 27 Dec 1907
11
Nathan Everett Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.2.1]
b. 6 Aug 1847 d. 10 May 1910
Hattie Edith Caldacott
b. 20 Mar 1858
12
Nathan Louis Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.2.1.1]
b. 6 Nov 1876 d. 1950
12
Edith Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.2.1.2]
b. 9 Sep 1878 [
=>
]
12
Ada Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.2.1.3]
b. 6 Oct 1879 d. 15 Aug 1880
11
Jeannette Whipple Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.2.2]
b. 2 Feb 1852 d. 20 Jan 1894
Richard Edwin Congdon
b. 16 May 1849 d. Aft 1909
12
Charles Everett Congdon
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.2.2.1]
c. 27 Sep 1873 d. 16 Oct 1944 [
=>
]
12
Frank Edwin Congdon
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.2.2.2]
b. 11 Sep 1875 [
=>
]
12
Abbie Reynolds Congdon
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.2.2.3]
b. 29 Jan 1879 d. 8 Nov 1922
12
Marion Congdon
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.2.2.4]
b. 26 Mar 1888 [
=>
]
12
Nettie Congdon
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.2.2.5]
b. 9 Jul 1891 d. 20 May 1991
11
Mattie Denning Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.2.3]
b. 12 May 1858 d. 20 Mar 1893
Charles Francis Ivers
b. 1 Jan 1856 d. 19 Nov 1934
12
Helen Louise Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.2.3.1]
b. 4 Jul 1883 d. 28 Sep 1954
11
Annie Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.2.4]
b. 24 Apr 1867 d. 10 Jan 1940
John McKinstry Merriam
b. 20 Sep 1862 d. 9 Jan 1959
12
Paul Adams Merriam
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.2.4.1]
b. 10 Jan 1889 d. Jul 1969 [
=>
]
12
Emily Davenport Merriam
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.2.4.2]
b. 5 May 1891 d. Jul 1980 [
=>
]
12
Constance Elizabeth Merriam
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.2.4.3]
b. 3 Sep 1892 d. 19 Feb 1935
12
Joseph Chapman Merriam
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.2.4.4]
b. 20 Sep 1894 d. Nov 1976
11
Bertha Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.2.5]
b. 14 Oct 1868 d. 11 Aug 1938
Mary Watrous
b. 17 Jun 1811 d. 1845
11
Nathan Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.2.6]
b. 29 Dec 1829 d. 23 Aug 1830
11
Mary Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.2.7]
b. 24 Jan 1831 d. 5 Jul 1832
11
Phebe Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.2.8]
b. 6 Nov 1832 d. 16 Apr 1833
11
Mary Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.2.9]
b. 8 Feb 1834 d. 27 Sep 1834
11
Martha Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.2.10]
b. 9 Aug 1835 d. 17 Mar 1836
11
Sarah Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.2.11]
b. 5 Jan 1837 d. 2 Dec 1837
11
Nathan Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.2.12]
b. 8 Oct 1838 d. 15 Mar 1845
11
Mary D Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.2.13]
b. Mar 1841 d. 16 Nov 1925
Stearns Godfrey Davenport
b. 15 Sep 1841 d. 7 Mar 1912
12
Edward Davenport
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.2.13.1]
b. 22 Feb 1869 d. 1869
12
Frederick Chapman Davenport
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.2.13.2]
b. 8 Sep 1871 d. 3 Feb 1872
12
Edward Walter Davenport
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.2.13.3]
b. 20 Nov 1872 d. 18 Sep 1951 [
=>
]
12
Sumner Godfrey Davenport
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.2.13.4]
b. 6 Nov 1877 d. 7 Mar 1956 [
=>
]
11
Levi Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.2.14]
b. 19 Apr 1843 d. 20 Nov 1843
11
Phebe Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.2.15]
b. 5 Feb 1845 d. 3 May 1845
10
Abiah Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.3]
b. 18 Oct 1808 d. 8 May 1899
Zephaniah Watrous
b. 30 Oct 1806 d. 10 Jun 1868
11
Zephaniah Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.3.1]
b. 20 Jan 1829 d. 8 May 1829
11
Abiah Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.3.2]
b. 2 Jan 1831 d. 24 Sep 1836
11
Zephaniah Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.3.3]
b. 11 Dec 1835 d. 22 Jul 1836
11
Zephaniah Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.3.4]
b. 30 Aug 1837 d. 9 Jul 1838
11
Zephaniah Watrous, Jr
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.3.5]
b. 4 Aug 1839 d. 6 Dec 1861
+
Harriet Whipple
b. 18 May 1843 d. 23 Oct 1897
11
William Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.3.6]
b. 29 Dec 1841 d. 5 Jul 1842
11
Sarah Elvira Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.3.7]
b. 3 Jul 1843 d. 26 Jul 1872
11
Nathan Alexander Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.3.8]
b. 17 May 1846 d. 17 Jun 1860
11
Mary Elizabeth Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.3.9]
b. 16 Apr 1849 d. 17 May 1860
11
Elias Everett Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.3.10]
b. 4 Jun 1852 d. 1 Sep 1924
Mary Ann Adams Phillips
b. 17 Jun 1853 d. 10 May 1915
12
Mary Alice Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.3.10.1]
b. 28 Apr 1877 d. 28 Dec 1968 [
=>
]
12
Elias Arthur Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.3.10.2]
b. 25 Feb 1879 d. 5 Nov 1964
12
Lucy Emeline Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.3.10.3]
b. 28 Jul 1881 d. 1972
12
Laura Ella Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.3.10.4]
b. 15 Jul 1883 d. 12 Dec 1934
12
Zephaniah Williams "Zephie" Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.3.10.5]
b. 4 Mar 1888 [
=>
]
12
Nathan Louis Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.3.10.6]
b. 22 Sep 1891 d. Dec 1966 [
=>
]
12
Evangeline Martha Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.3.10.7]
b. 24 Apr 1896 d. May 1981
12
Roscoe Melvin Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.3.10.8]
b. 27 Oct 1898 d. Apr 1971
10
Timothy Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.4]
b. Mar 1810
10
Benjamin Franklin Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.5]
b. 13 Oct 1811 d. 29 Dec 1901
Nancy Cole Peabody
b. 13 Apr 1810 d. 19 Feb 1892
11
Benjamin F Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.5.1]
b. 1850 d. 1 Sep 1882
10
Ori Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.6]
b. 18 Sep 1813 d. 1898
Content Whipple
b. 20 Oct 1814 d. 1875
11
Ori Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.6.1]
b. 1836 d. 7 Apr 1865
Anetta Moffatt
b. 1846
12
Ida Lucretia Tracy
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.6.1.1]
b. 6 Jan 1881
12
Arthur Tracy
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.6.1.2]
b. 4 Oct 1888 [
=>
]
11
Nathan Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.6.2]
b. 1838 d. 1857
11
Noah Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.6.3]
b. 1840 d. 26 Apr 1915
Lucinda F Till
b. 1843 d. 11 Jul 1908
12
Lucy I Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.6.3.1]
b. 1866
12
Courtland W Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.6.3.2]
b. 1868 d. 27 Mar 1952
12
Guy C Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.6.3.3]
b. 1871 d. 22 Aug 1938 [
=>
]
12
Katie E Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.6.3.4]
b. 1880 [
=>
]
11
Content Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.6.4]
b. 20 Mar 1842 d. 26 Apr 1915
Nelson Clark Shafer
b. 12 Jul 1830 d. 14 Oct 1902
12
Nathan Ralph Shafer
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.6.4.1]
b. 12 May 1858 d. 26 May 1938 [
=>
]
12
Charles Davis Shafer
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.6.4.2]
b. Abt 1863 d. May 1948 [
=>
]
12
Fredrick Loren Shafer
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.6.4.3]
b. 14 Jun 1864 d. Aug 1865
12
Alonzo Clark Shafer
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.6.4.4]
b. 21 Jan 1868 d. 28 Aug 1948 [
=>
]
12
Daughter Shafer
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.6.4.5]
b. 1870 d. 1870
12
Sarah Content Shafer
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.6.4.6]
b. Mar 1872 d. 14 Mar 1938 [
=>
]
12
Ori Everett Shafer
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.6.4.7]
b. 22 Sep 1875 d. Nov 1875
12
Louella Cornelia Shafer
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.6.4.8]
b. 7 Nov 1877 d. 28 Nov 1877
12
Ruth Mae Shafer
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.6.4.9]
b. 18 Mar 1880 d. 25 Oct 1957 [
=>
]
12
Agnes Amy Shafer
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.6.4.10]
b. 9 Aug 1883 d. 12 Sep 1930
12
Alfred Clark Shafer
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.6.4.11]
b. 9 May 1885 d. 30 May 1919
11
Betsey Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.6.5]
b. Abt 1845 d. 9 Jan 1848
11
Abel T Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.6.6]
b. 30 Mar 1847 d. 15 Dec 1875
Lena Adelia Smith
b. 8 Oct 1854 d. 23 Aug 1913
12
Ori Edwin Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.6.6.1]
b. 13 Nov 1873 d. 23 Jul 1943 [
=>
]
11
Lucy E Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.6.7]
b. 9 Jan 1848
11
Loran C Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.6.8]
b. 23 Apr 1850
Rose Ann Markie
b. 1851
12
Daniel Ori Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.6.8.1]
b. Abt 1871
12
Lucy Ester Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.6.8.2]
b. 20 Mar 1874
12
Edward J Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.6.8.3]
b. 1877
12
Louella Cornelia Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.6.8.4]
b. Abt 1880
12
Rosa Belle Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.6.8.5]
b. Abt 1881
12
Charles Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.6.8.6]
b. Abt 1884
11
William Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.9.6.9]
b. Abt 1852
9
Zephaniah Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.10]
b. 23 Apr 1785 d. 1858
Sarah Rogers
b. 26 Apr 1783
10
Zephaniah Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.1]
b. 30 Oct 1806 d. 10 Jun 1868
Abiah Chapman
b. 18 Oct 1808 d. 8 May 1899
11
Zephaniah Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.1.1]
b. 20 Jan 1829 d. 8 May 1829
11
Abiah Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.1.2]
b. 2 Jan 1831 d. 24 Sep 1836
11
Zephaniah Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.1.3]
b. 11 Dec 1835 d. 22 Jul 1836
11
Zephaniah Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.1.4]
b. 30 Aug 1837 d. 9 Jul 1838
11
Zephaniah Watrous, Jr
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.1.5]
b. 4 Aug 1839 d. 6 Dec 1861
+
Harriet Whipple
b. 18 May 1843 d. 23 Oct 1897
11
William Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.1.6]
b. 29 Dec 1841 d. 5 Jul 1842
11
Sarah Elvira Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.1.7]
b. 3 Jul 1843 d. 26 Jul 1872
11
Nathan Alexander Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.1.8]
b. 17 May 1846 d. 17 Jun 1860
11
Mary Elizabeth Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.1.9]
b. 16 Apr 1849 d. 17 May 1860
11
Elias Everett Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.1.10]
b. 4 Jun 1852 d. 1 Sep 1924
Mary Ann Adams Phillips
b. 17 Jun 1853 d. 10 May 1915
12
Mary Alice Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.1.10.1]
b. 28 Apr 1877 d. 28 Dec 1968 [
=>
]
12
Elias Arthur Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.1.10.2]
b. 25 Feb 1879 d. 5 Nov 1964
12
Lucy Emeline Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.1.10.3]
b. 28 Jul 1881 d. 1972
12
Laura Ella Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.1.10.4]
b. 15 Jul 1883 d. 12 Dec 1934
12
Zephaniah Williams "Zephie" Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.1.10.5]
b. 4 Mar 1888 [
=>
]
12
Nathan Louis Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.1.10.6]
b. 22 Sep 1891 d. Dec 1966 [
=>
]
12
Evangeline Martha Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.1.10.7]
b. 24 Apr 1896 d. May 1981
12
Roscoe Melvin Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.1.10.8]
b. 27 Oct 1898 d. Apr 1971
10
Sarah Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.2]
b. 22 May 1808
10
Esther Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.3]
b. 29 Nov 1809 d. Apr 1903
Alexander Watrous
b. 1804 d. 1836
11
Esther Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.3.1]
b. 1833 d. 1868
John Crouch Chapman
b. 18 Jun 1832 d. 22 Jan 1893
12
Augusta Estelle Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.3.1.1]
b. 29 May 1853 d. 1 Jul 1901 [
=>
]
12
Martha E Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.3.1.2]
b. 1855 d. Abt 1856
12
Elbert A Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.3.1.3]
b. 6 Sep 1857 d. 5 Jun 1887
12
Elias A Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.3.1.4]
b. 1860 d. Apr 1883
12
Martha Esther Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.3.1.5]
b. 22 Feb 1862 d. 24 Mar 1946 [
=>
]
12
Mary Ellen Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.3.1.6]
b. 11 May 1864 d. 31 Jul 1950 [
=>
]
11
Desire Amelia Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.3.2]
b. 11 Aug 1836 d. 4 Apr 1912
Daniel Elvin Crouch
b. 19 Sep 1834 d. 26 Feb 1865
12
George E Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.3.2.1]
b. 5 Mar 1858 d. 1 May 1858
12
Daniel Elvin Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.3.2.2]
b. 18 Dec 1860
12
Zephaniah William Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.3.2.3]
b. 19 Aug 1862 d. 26 Mar 1886
12
Franklin Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.3.2.4]
b. 3 Jun 1864 d. 22 Nov 1885
12
Amy Ester Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.3.2.5]
b. 23 Jan 1866 d. 23 Jan 1946 [
=>
]
12
Esther Eva Crouch
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.3.2.6]
b. 5 Jun 1859 d. 13 Jan 1923 [
=>
]
10
Mary Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.4]
b. 17 Jun 1811 d. 1845
Nathan Chapman
b. 27 Mar 1807 d. 28 Nov 1885
11
Nathan Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.4.1]
b. 29 Dec 1829 d. 23 Aug 1830
11
Mary Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.4.2]
b. 24 Jan 1831 d. 5 Jul 1832
11
Phebe Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.4.3]
b. 6 Nov 1832 d. 16 Apr 1833
11
Mary Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.4.4]
b. 8 Feb 1834 d. 27 Sep 1834
11
Martha Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.4.5]
b. 9 Aug 1835 d. 17 Mar 1836
11
Sarah Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.4.6]
b. 5 Jan 1837 d. 2 Dec 1837
11
Nathan Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.4.7]
b. 8 Oct 1838 d. 15 Mar 1845
11
Mary D Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.4.8]
b. Mar 1841 d. 16 Nov 1925
Stearns Godfrey Davenport
b. 15 Sep 1841 d. 7 Mar 1912
12
Edward Davenport
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.4.8.1]
b. 22 Feb 1869 d. 1869
12
Frederick Chapman Davenport
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.4.8.2]
b. 8 Sep 1871 d. 3 Feb 1872
12
Edward Walter Davenport
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.4.8.3]
b. 20 Nov 1872 d. 18 Sep 1951 [
=>
]
12
Sumner Godfrey Davenport
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.4.8.4]
b. 6 Nov 1877 d. 7 Mar 1956 [
=>
]
11
Levi Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.4.9]
b. 19 Apr 1843 d. 20 Nov 1843
11
Phebe Chapman
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.4.10]
b. 5 Feb 1845 d. 3 May 1845
10
Reuben Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.5]
b. 17 Dec 1812
10
Amy Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.6]
b. 3 Jul 1815
10
Phebe Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.7]
b. 13 Jun 1818
10
Stephen Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.8]
b. 16 Nov 1820
10
Timothy Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.9]
b. Abt 1822
10
Rachel Watrous
[1.1.4.1.3.2.7.7.10.10]
b. Abt 1824
8
Zachariah Whipple
[1.1.4.1.3.2.7.8]
b. 6 Jun 1745
7
Zephaniah Whipple
[1.1.4.1.3.2.8]
b. 1709 d. 1760
Kesiah Parke
b. Abt 1700 d. Aft 4 Apr 1769
8
Solomon Whipple
[1.1.4.1.3.2.8.1]
b. 26 Jul 1743 d. Bef 4 Apr 1769
8
Zephaniah Whipple
[1.1.4.1.3.2.8.2]
b. Abt 1746 d. Bef 1800
8
Elijah Whipple
[1.1.4.1.3.2.8.3]
b. Abt 1748 d. Aft 1826
8
Isaiah Whipple
[1.1.4.1.3.2.8.4]
b. Abt 1750
7
Elizabeth Whipple
[1.1.4.1.3.2.9]
b. Feb 1718 d. Nov 1718
6
Thomas Whipple
[1.1.4.1.3.3]
b. Abt 1671 d. 31 Mar 1766
Abigail Jenckes
b. 1676 d. 12 Mar 1756
7
Mary Harris Whipple
[1.1.4.1.3.3.1]
b. Abt 1697
7
Thomas Whipple, Jr
[1.1.4.1.3.3.2]
b. Abt 1698 d. 20 Nov 1771
Mary Gary
b. 20 Jul 1699 d. 21 Feb 1767
8
Thomas Whipple, III
[1.1.4.1.3.3.2.1]
b. 16 Jul 1723
Abigail Wood
9
Noah Whipple
[1.1.4.1.3.3.2.1.1]
b. 23 Apr 1747
9
Ann Whipple
[1.1.4.1.3.3.2.1.2]
b. 17 Jan 1749
9
Noah Whipple
[1.1.4.1.3.3.2.1.3]
b. 3 May 1753
8
Mary Whipple
[1.1.4.1.3.3.2.2]
b. 23 Jul 1725 d. Nov 1763
Moses Pelton
b. 1728 d. 16 Apr 1778
9
Hannah Pelton
[1.1.4.1.3.3.2.2.1]
b. 3 Jan 1749 d. 10 May 1754
9
Moses Pelton, Jr
[1.1.4.1.3.3.2.2.2]
b. 27 Jun 1751 d. 19 Jun 1809
9
Joel Pelton
[1.1.4.1.3.3.2.2.3]
b. 5 Nov 1752 d. 7 Mar 1856
9
Mary Pelton
[1.1.4.1.3.3.2.2.4]
b. 26 Feb 1754
9
Hannah Pelton
[1.1.4.1.3.3.2.2.5]
b. 30 Aug 1755 d. 16 Feb 1817
9
Lemuel Pelton
[1.1.4.1.3.3.2.2.6]
b. 1757
9
Elizabeth Pelton
[1.1.4.1.3.3.2.2.7]
b. Nov 1763
8
Abigail Whipple
[1.1.4.1.3.3.2.3]
b. 8 Jun 1727 d. 14 Jan 1728
8
Abraham Whipple
[1.1.4.1.3.3.2.4]
b. 16 Feb 1728 d. 11 Mar 1729
8
Abigail Whipple
[1.1.4.1.3.3.2.5]
b. 30 Jan 1729 d. 21 Apr 1806
Elijah Miner
b. Abt 1732 d. 18 Aug 1756
9
Abigail Miner
[1.1.4.1.3.3.2.5.1]
b. 24 Dec 1756
9
Christiana Miner
[1.1.4.1.3.3.2.5.2]
b. 29 Dec 1751 d. 24 Jun 1808
Thomas Davis
10
Elijah Davis
[1.1.4.1.3.3.2.5.2.1]
b. 30 Jun 1775 d. 26 Feb 1834
10
Thomas Davis
[1.1.4.1.3.3.2.5.2.2]
b. 13 Nov 1777
10
Sarah Davis
[1.1.4.1.3.3.2.5.2.3]
b. 25 Apr 1780 d. 20 Aug 1848
10
Levina Davis
[1.1.4.1.3.3.2.5.2.4]
b. 18 Apr 1782
10
Roswell Davis
[1.1.4.1.3.3.2.5.2.5]
b. 18 Feb 1785 d. 14 May 1848
10
Polly Davis
[1.1.4.1.3.3.2.5.2.6]
b. 31 Jul 1791 d. 28 Apr 1794
Jonathan Dickinson
b. 18 Nov 1738 d. 16 Oct 1762
9
Mary Dickinson
[1.1.4.1.3.3.2.5.3]
b. 25 Dec 1758 d. 5 Mar 1759
9
Jonathan Dickinson
[1.1.4.1.3.3.2.5.4]
b. 30 Sep 1760
9
Mary Dickinson
[1.1.4.1.3.3.2.5.5]
b. Mar 1762 d. May 1850
Isaac Buck
b. 1739 d. 6 Feb 1825
9
Elijah Buck
[1.1.4.1.3.3.2.5.6]
b. 11 Apr 1760 d. 24 Aug 1852
+
Submit Willson
b. 1765
9
Isaac Buck, Jr
[1.1.4.1.3.3.2.5.7]
b. 11 Sep 1762
9
Susannah Buck
[1.1.4.1.3.3.2.5.8]
b. 16 Dec 1764
9
William Buck
[1.1.4.1.3.3.2.5.9]
b. 3 Nov 1766
9
Sarah Buck
[1.1.4.1.3.3.2.5.10]
b. 22 Apr 1769 d. 1858
Samuel Parsons
b. 1767
10
Clarissa Parsons
[1.1.4.1.3.3.2.5.10.1]
b. 21 Mar 1791 d. 23 Jan 1849
Jonathan Butterfield
b. 10 Dec 1777 d. 10 Apr 1846
11
Jonathan Butterfield
[1.1.4.1.3.3.2.5.10.1.1]
b. 30 Sep 1806 d. 5 Nov 1880
Jane Wilson
b. 1807 d. 9 Oct 1832
12
John Schyler Butterfield
[1.1.4.1.3.3.2.5.10.1.1.1]
b. 1830
12
Augusta Butterfield
[1.1.4.1.3.3.2.5.10.1.1.2]
b. 1832
Mary Perry
b. 3 Aug 1809
12
Jane R. Butterfield
[1.1.4.1.3.3.2.5.10.1.1.3]
b. 1835
12
Sarah C. Butterfield
[1.1.4.1.3.3.2.5.10.1.1.4]
b. 1837
12
Cornelia Butterfield
[1.1.4.1.3.3.2.5.10.1.1.5]
b. 1838
12
Ann E. Butterfield
[1.1.4.1.3.3.2.5.10.1.1.6]
b. 1840
12
Clarissa A. Butterfield
[1.1.4.1.3.3.2.5.10.1.1.7]
b. 1842 [
=>
]
12
Oliver P. Butterfield
[1.1.4.1.3.3.2.5.10.1.1.8]
b. Abt 1844 [
=>
]
11
George Butterfield
[1.1.4.1.3.3.2.5.10.1.2]
b. 4 Sep 1808 d. 22 Nov 1808
11
Perses B Butterfield
[1.1.4.1.3.3.2.5.10.1.3]
b. 5 Sep 1811 d. 11 Feb 1893
Albert M. Skellenger
b. 14 Oct 1805 d. 13 May 1888
12
Jesse Leander Skellenger
[1.1.4.1.3.3.2.5.10.1.3.1]
b. 28 Jan 1830 d. 18 Jul 1900 [
=>
]
12
Cordelia M Skellenger
[1.1.4.1.3.3.2.5.10.1.3.2]
b. 1832
12
Albert F Skellenger
[1.1.4.1.3.3.2.5.10.1.3.3]
b. 28 Jan 1830 d. 2 Feb 1917 [
=>
]
12
Sarah Ann Skellenger
[1.1.4.1.3.3.2.5.10.1.3.4]
b. 1834 d. 20 Jan 1892 [
=>
]
11
Clarissa Butterfield
[1.1.4.1.3.3.2.5.10.1.4]
b. 27 Jul 1812 d. 4 Nov 1894
Daniel Drury Ashley
b. 5 Aug 1810 d. 3 Jan 1893
12
William Henry Ashley
[1.1.4.1.3.3.2.5.10.1.4.1]
b. 11 Oct 1833 d. 17 Apr 1863
12
Cooper Nathaniel Ashley
[1.1.4.1.3.3.2.5.10.1.4.2]
b. 25 Dec 1835 d. 20 Jun 1894
12
Hetty Clarissa Ashley
[1.1.4.1.3.3.2.5.10.1.4.3]
b. 26 Sep 1837 d. 23 Jul 1840
12
Hetty Cooper Ashley
[1.1.4.1.3.3.2.5.10.1.4.4]
b. 10 May 1840 [
=>
]
12
Sylvia Maria Ashley
[1.1.4.1.3.3.2.5.10.1.4.5]
b. 2 Apr 1842
12
Alice Amelia Ashley
[1.1.4.1.3.3.2.5.10.1.4.6]
b. 11 Dec 1848 d. 10 Mar 1849
11
Sarah Butterfield
[1.1.4.1.3.3.2.5.10.1.5]
b. 20 Aug 1814 d. 22 Sep 1814
11
Charles B Butterfield
[1.1.4.1.3.3.2.5.10.1.6]
b. 10 Aug 1815 d. 14 Feb 1886
11
Isaac Butterfield
[1.1.4.1.3.3.2.5.10.1.7]
b. 24 Jan 1817 d. 20 May 1878
Susan Thompson
b. 1818
12
Wanitta Marietta Butterfield
[1.1.4.1.3.3.2.5.10.1.7.1]
b. 1847
12
Alice C Butterfield
[1.1.4.1.3.3.2.5.10.1.7.2]
b. 1850
12
Arthur C Butterfield
[1.1.4.1.3.3.2.5.10.1.7.3]
b. 1850
11
Harriet A Butterfield
[1.1.4.1.3.3.2.5.10.1.8]
b. 24 Oct 1819
Orrin N Thayer
b. 11 Aug 1817
12
Ellen Laura Thayer
[1.1.4.1.3.3.2.5.10.1.8.1]
b. 29 Aug 1842
12
Orson Allertus Thayer
[1.1.4.1.3.3.2.5.10.1.8.2]
b. 4 Aug 1845
11
David L Butterfield
[1.1.4.1.3.3.2.5.10.1.9]
b. 4 Apr 1823
Sarah Miranda Stover
b. 1826
12
Eugene Uzeen Butterfield
[1.1.4.1.3.3.2.5.10.1.9.1]
b. 1849
11
Rachel M Butterfield
[1.1.4.1.3.3.2.5.10.1.10]
b. 24 Jun 1825
+
Henry Vandercook
b. 1821
11
Mary Etta Butterfield
[1.1.4.1.3.3.2.5.10.1.11]
b. 6 Sep 1827 d. 17 Apr 1874
+
Hiram B Bullard
b. 2 Oct 1825 d. 22 Jul 1885
11
Celestine P Butterfield
[1.1.4.1.3.3.2.5.10.1.12]
b. 13 Mar 1830
William Palmer Blake
b. 7 Jun 1828
12
Clara A Blake
[1.1.4.1.3.3.2.5.10.1.12.1]
b. 1852
12
Mary G Blake
[1.1.4.1.3.3.2.5.10.1.12.2]
b. 1863
12
Francis A Blake
[1.1.4.1.3.3.2.5.10.1.12.3]
b. 1865 [
=>
]
10
Parmelia Parsons
[1.1.4.1.3.3.2.5.10.2]
b. 12 Oct 1793
10
Harvey Parsons
[1.1.4.1.3.3.2.5.10.3]
b. 3 Sep 1795 d. 28 Mar 1861
10
Samuel Parsons
[1.1.4.1.3.3.2.5.10.4]
b. 19 Nov 1797
10
Elijah Parsons
[1.1.4.1.3.3.2.5.10.5]
b. 1800
10
Lyman Parsons
[1.1.4.1.3.3.2.5.10.6]
b. 10 Jun 1801 d. 5 Nov 1883
10
Sally Parsons
[1.1.4.1.3.3.2.5.10.7]
b. 26 Jun 1803
10
Amity Parsons
[1.1.4.1.3.3.2.5.10.8]
b. 1806 d. 23 Oct 1806
10
Orrin Parsons
[1.1.4.1.3.3.2.5.10.9]
b. 3 Jul 1807
10
Elam Parsons
[1.1.4.1.3.3.2.5.10.10]
b. 2 Aug 1809 d. 1893
10
Lucina Parsons
[1.1.4.1.3.3.2.5.10.11]
b. 1811 d. 11 Nov 1879
10
Lura Amity Parsons
[1.1.4.1.3.3.2.5.10.12]
b. 20 Aug 1813
9
Elenor Buck
[1.1.4.1.3.3.2.5.11]
b. 15 Jun 1771
9
Lavina Buck
[1.1.4.1.3.3.2.5.12]
b. 11 Dec 1773
8
Nathan Whipple
[1.1.4.1.3.3.2.6]
b. 24 Dec 1731 d. 19 Mar 1813
Hannah White
b. 22 Aug 1729
9
Hannah Whipple
[1.1.4.1.3.3.2.6.1]
b. 15 Apr 1758
9
Atener Whipple
[1.1.4.1.3.3.2.6.2]
b. 4 Apr 1763
9
Thomas Whipple
[1.1.4.1.3.3.2.6.3]
b. 23 Oct 1760
9
Nathan Whipple
[1.1.4.1.3.3.2.6.4]
b. 30 Mar 1766 d. 1 Jul 1832
9
Susannah Whipple
[1.1.4.1.3.3.2.6.5]
b. 18 Jan 1754
9
Patience Whipple
[1.1.4.1.3.3.2.6.6]
b. 19 Jan 1756
8
Rachel Whipple
[1.1.4.1.3.3.2.7]
b. 13 Oct 1733
Captain Nathaniel Hamlin
b. 7 Jan 1739 d. 27 Dec 1818
9
Charity Hamblin
[1.1.4.1.3.3.2.7.1]
b. 30 Jan 1755
9
Levi Hamblin
[1.1.4.1.3.3.2.7.2]
b. 11 Jun 1757
9
John Hamlin
[1.1.4.1.3.3.2.7.3]
b. 12 Mar 1761 d. 30 Oct 1825
9
William Hamblin
[1.1.4.1.3.3.2.7.4]
b. 17 May 1763
9
Asrariah Hamblin
[1.1.4.1.3.3.2.7.5]
b. 27 Mar 1765
8
Ann Whipple
[1.1.4.1.3.3.2.8]
b. 21 Oct 1735
Isaac Wyborn
b. 1727 d. Aft 1802
9
Prudence Wyborn
[1.1.4.1.3.3.2.8.1]
b. 1762
9
William Gershon Wyborn
[1.1.4.1.3.3.2.8.2]
b. 24 Jan 1777 d. 22 Mar 1857
9
Lucy Wyborn
[1.1.4.1.3.3.2.8.3]
b. 1778
9
John M Wyborn
[1.1.4.1.3.3.2.8.4]
b. Abt 1779
9
Bevil Granville Wyborn
[1.1.4.1.3.3.2.8.5]
b. 15 Oct 1783 d. 9 May 1872
9
Daughter Wyborn
[1.1.4.1.3.3.2.8.6]
b. Abt 1789
8
Elizabeth Whipple
[1.1.4.1.3.3.2.9]
b. 26 Feb 1739
8
Amos Whipple
[1.1.4.1.3.3.2.10]
b. 22 Jan 1742
7
Enoch Whipple
[1.1.4.1.3.3.3]
b. Abt 1703 d. 18 Jan 1725
7
Abraham Whipple
[1.1.4.1.3.3.4]
b. Abt 1709 d. 3 Oct 1768
Mary Jones
b. 22 Apr 1709 d. 4 Nov 1780
8
Bathsheba Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.1]
b. 2 Feb 1731
8
Abraham Whipple, Jr
[1.1.4.1.3.3.4.2]
b. 18 Mar 1734
8
Mary Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.3]
b. 1 Mar 1735 d. 6 Dec 1823
8
Samuel Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.4]
b. 7 Jan 1737 d. 28 Sep 1762
+
Oliver Evans
b. Abt 1741
8
Joseph Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.5]
b. 18 May 1740
Abigail Gary
b. 2 Jul 1743
9
Abraham Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.5.1]
b. 11 Feb 1768 d. 12 Jan 1852
8
Luther Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6]
b. 7 Mar 1743 d. 1830
Eunice Gates
b. Abt 1744
9
Abram Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1]
b. 11 Feb 1768 d. 12 Jan 1852
Asenath Sumner
b. 2 Aug 1768 d. 23 Dec 1851
10
Abigail Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.1]
b. 1794 d. 13 Apr 1870
Isaac Coon
b. 25 Apr 1792 d. 5 Jan 1878
11
Lucinda Coon
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.1.1]
b. 1815 d. 7 Apr 1881
10
Louisa Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.2]
b. 1798 d. 12 Apr 1889
10
Eunice Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.3]
b. 1800
10
Daniel Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.4]
b. 20 Nov 1801 d. 26 Apr 1889
Maria Chamberlain
b. 9 Aug 1825 d. 31 Dec 1891
11
Jane Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.4.1]
b. 14 Nov 1850 d. 19 Jul 1932
11
Jerome Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.4.2]
b. 17 Mar 1853 d. 17 Nov 1921
11
Abraham Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.4.3]
b. May 1863
11
Elizabeth Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.4.4]
b. 1866 d. 1937
11
Sarah Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.4.5]
b. 23 Feb 1869 d. 24 Apr 1895
10
Asenath "Sena" Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.5]
b. 1803 d. 27 May 1896
Lyman Hoyt
b. 1804
11
Lucy Ann Hoyt
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.5.1]
b. Abt 1834 d. 26 Feb 1920
Alexander M Thompson
b. Abt 1825 d. 27 Mar 1882
12
Jennie A Thompson
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.5.1.1]
b. Oct 1858 d. 28 Jun 1900
12
Asenath J Thompson
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.5.1.2]
b. 1859
12
Martha A Thompson
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.5.1.3]
b. 1862
11
Mary Hoyt
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.5.2]
b. Abt 1836
11
Sarah Hoyt
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.5.3]
b. Abt 1838
11
Lois Hoyt
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.5.4]
b. Abt 1844 d. Bef 1860
11
Esther Hoyt
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.5.5]
b. Abt 1846
11
Henry V Hoyt
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.5.6]
b. 27 Feb 1850 d. 10 Sep 1933
10
Lydia Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.6]
b. 1806 d. 19 Sep 1880
Jacob Mead
b. 3 Aug 1807 d. 14 Oct 1880
11
Aseneth Mead
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.6.1]
b. 17 Dec 1831 d. 29 Apr 1844
10
Henry Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.7]
b. 22 May 1807 d. 13 Jan 1895
Polly Ellis
b. 22 Mar 1816
11
Harrison Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.7.1]
b. 1835
11
Gardner C Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.7.2]
b. 12 Aug 1849 d. 25 Sep 1926
11
Betsey Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.7.3]
b. 1850
11
Caroline Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.7.4]
b. 1851
11
Adelbert Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.7.5]
b. Oct 1854 d. 1936
11
Warren Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.7.6]
b. Aug 1863 d. 25 Apr 1915
+
Margaret Bertha Tracy
b. 1870
10
George "Leo" Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.8]
b. 18 May 1809 d. 19 Jul 1896
Sarah Maritta Stratter
b. 9 Jan 1811 d. 31 Aug 1889
11
Mary E Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.8.1]
b. Feb 1838 d. 11 Feb 1917
Hiram Knickerbocker Mott
b. 18 May 1838 d. 5 May 1914
12
George W Mott
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.8.1.1]
b. 13 Oct 1859 [
=>
]
12
John Stratton Mott
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.8.1.2]
b. 30 Jun 1863 d. 13 Sep 1933
12
Sarah M Mott
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.8.1.3]
b. 24 May 1866 [
=>
]
12
Omar D Mott
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.8.1.4]
b. 9 Feb 1870 d. 5 Jun 1914
12
Hezekiah H Mott
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.8.1.5]
b. 17 Jun 1872
12
Andrew C Mott
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.8.1.6]
b. 4 Apr 1874 d. 11 Jul 1957
12
Kiah C Mott
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.8.1.7]
b. 17 Jun 1876
11
Jonathan S Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.8.2]
b. 1840 d. 1933
11
Judson A Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.8.3]
b. 9 Jul 1847 d. 25 Jan 1931
Helen A Morse
b. 12 Sep 1846 d. 11 Dec 1922
12
Clara Mae Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.8.3.1]
b. 6 Jan 1871 d. 20 Apr 1962
12
Frederick Warren Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.8.3.2]
b. 2 Nov 1873 d. 9 Apr 1952
12
Eliza Marietta Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.8.3.3]
b. 13 Sep 1875 d. 30 Oct 1911
12
Arthur J Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.8.3.4]
b. 25 Mar 1877 d. 25 Mar 1955
12
Nettie E Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.8.3.5]
b. 24 Jan 1879 bur. 1931
12
George S Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.8.3.6]
b. 13 May 1880 d. 2 Dec 1963
12
Lena "Nora" Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.8.3.7]
b. 16 Nov 1883 d. 3 Aug 1973
11
Daniel Burdette Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.8.4]
b. 1853 d. 1922
10
Abraham Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.9]
b. 1810 d. Abt 1888
Catherine Smith
b. Oct 1819 d. Aft 1900
11
Isaac Conrad Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.9.1]
b. 4 Mar 1838 d. 24 May 1927
Margaret Catherine Falkner
b. 27 May 1843 d. 5 Dec 1917
12
Abraham Lincoln "Abegiell" Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.9.1.1]
b. 15 Sep 1865 d. 10 May 1940 [
=>
]
12
Caroline Bertha Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.9.1.2]
b. 13 Dec 1866 d. 16 Apr 1946 [
=>
]
12
Charles A Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.9.1.3]
b. 26 Jan 1868 d. 1927
12
John Peter Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.9.1.4]
b. 18 Oct 1869 d. 16 Jul 1955 [
=>
]
12
Idella "Ida" Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.9.1.5]
b. 9 Aug 1871 d. 1950
12
George William Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.9.1.6]
b. 8 Sep 1872 d. 20 Mar 1929 [
=>
]
12
Albert A "Bert" Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.9.1.7]
b. 6 Aug 1875 d. 1945
12
Mary Ann Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.9.1.8]
b. 21 Sep 1877 d. 19 Aug 1942 [
=>
]
12
Margaret Carrie Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.9.1.9]
b. 19 Feb 1880 d. 19 Feb 1929
11
Agnes Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.9.2]
b. May 1839 d. 1930
11
Catherine Minerva Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.9.3]
b. 1840
Frailand Morehouse
b. 1832
12
Son Morehouse
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.9.3.1]
b. 1860
12
Ina Morehouse
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.9.3.2]
b. 1880
11
Alena Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.9.4]
b. 1841
11
Julia Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.9.5]
b. 1843
11
Richard Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.9.6]
b. 1845
Phebe Woolheater
b. 1842 d. 1910
12
Frederick Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.9.6.1]
b. 1867 d. 19 Mar 1945
12
Henry Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.9.6.2]
b. 1872
12
Francis Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.9.6.3]
b. 1879
+
Joanna Green
b. 1860 d. 1936
11
Abraham Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.9.7]
b. 1847
11
Lavinda Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.9.8]
b. 1853 d. 10 Oct 1878
11
Ida Jane Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.9.9]
b. Abt 1858
11
George B Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.9.10]
b. Abt 1862
11
Abby Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.9.11]
b. Abt 1874
10
Caroline Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.10]
b. 1811
10
Jane Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.1.11]
b. 1812 d. 3 Aug 1872
9
Eunice Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.2]
b. 18 Mar 1770 d. 26 Feb 1863
9
Polly Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.3]
b. 1772 d. 24 Aug 1847
Thomas Whittlesey
b. 28 Feb 1772 d. 2 Mar 1847
10
Lucy Whittlesey
[1.1.4.1.3.3.4.6.3.1]
b. Jun 1797 d. Jul 1865
10
Maria Whittlesey
[1.1.4.1.3.3.4.6.3.2]
b. 9 Apr 1805
10
Eliza Whittlesey
[1.1.4.1.3.3.4.6.3.3]
b. 19 Aug 1807 d. Abt 1831
George Peck
b. 1810
11
Nancy Maria Peck
[1.1.4.1.3.3.4.6.3.3.1]
b. 30 May 1833 d. 8 Jul 1911
Charles Giles Myers
b. 16 Mar 1830 d. 1 Jun 1910
12
Eureka N Myers
[1.1.4.1.3.3.4.6.3.3.1.1]
b. 1857
12
Charles Chester Myers
[1.1.4.1.3.3.4.6.3.3.1.2]
b. 6 May 1858 d. 12 Feb 1944 [
=>
]
12
Alma Alfaretta Myers
[1.1.4.1.3.3.4.6.3.3.1.3]
b. 10 Nov 1872 d. 8 Sep 1952 [
=>
]
10
Thomas Jefferson Whittlesey
[1.1.4.1.3.3.4.6.3.4]
b. 13 Jun 1812
10
Isaac Whittlesey
[1.1.4.1.3.3.4.6.3.5]
b. 25 Mar 1815
Adelaide Shailor
b. 13 Sep 1819 d. 18 Feb 1856
11
Josephine Ann Whittlesey
[1.1.4.1.3.3.4.6.3.5.1]
b. 28 Apr 1847 d. 2 Mar 1850
11
Charles Chester Whittlesey
[1.1.4.1.3.3.4.6.3.5.2]
b. 28 Nov 1851
11
Adelaide Maria Whittlesey
[1.1.4.1.3.3.4.6.3.5.3]
b. 28 Jan 1855
+
Charles Parks
b. Abt 1851
10
Francis Elmira Whittlesey
[1.1.4.1.3.3.4.6.3.6]
b. 30 Sep 1817
9
Elizabeth Gates Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.4]
b. 19 Aug 1775 d. 26 Jun 1862
John Sawyer
b. 10 May 1773 d. 21 Apr 1871
10
Abraham Sawyer
[1.1.4.1.3.3.4.6.4.1]
b. 1 Feb 1796 d. 9 Apr 1868
10
John Sawyer
[1.1.4.1.3.3.4.6.4.2]
b. 14 Apr 1805 d. 26 Feb 1880
Elizabeth Quick
b. 15 May 1807 d. 1901
11
Lewis Sawyer
[1.1.4.1.3.3.4.6.4.2.1]
b. 23 Aug 1825
11
Hiram Sawyer
[1.1.4.1.3.3.4.6.4.2.2]
b. 26 Jun 1826 d. 14 Mar 1913
+
Phoebe Jane Teed
b. 23 Aug 1829 d. 6 Mar 1908
11
Sarah A Sawyer
[1.1.4.1.3.3.4.6.4.2.3]
b. 24 Sep 1837 d. 30 Nov 1918
William Dunham
b. 11 Aug 1837 d. 20 Jun 1886
12
Rose Ann Dunham
[1.1.4.1.3.3.4.6.4.2.3.1]
b. Abt 1865 [
=>
]
12
Wilson C Dunham
[1.1.4.1.3.3.4.6.4.2.3.2]
b. 1873
12
Nellia Dunham
[1.1.4.1.3.3.4.6.4.2.3.3]
b. 1875
10
Issac Sawyer
[1.1.4.1.3.3.4.6.4.3]
b. 3 Sep 1816 d. 1 Jul 1912
10
Ira Sawyer
[1.1.4.1.3.3.4.6.4.4]
b. 3 Sep 1816 d. 28 Nov 1899
Damaris Burrows
b. 4 Oct 1828 d. 29 Mar 1929
11
Franklin W Sawyer
[1.1.4.1.3.3.4.6.4.4.1]
b. 20 Apr 1855 d. 14 Aug 1941
11
Jasper Sawyer
[1.1.4.1.3.3.4.6.4.4.2]
b. 1857 d. Bef 1870
11
John L Sawyer
[1.1.4.1.3.3.4.6.4.4.3]
b. Oct 1858 d. 25 Jan 1915
Catherine M
b. Jan 1865
12
Charles Leslie
[1.1.4.1.3.3.4.6.4.4.3.1]
b. Aug 1892
11
Luther D Sawyer
[1.1.4.1.3.3.4.6.4.4.4]
b. 1860
Katheryn
b. 1865
12
Maud M Sawyer
[1.1.4.1.3.3.4.6.4.4.4.1]
b. 1893
11
Sarah Sawyer
[1.1.4.1.3.3.4.6.4.4.5]
b. Abt Jun 1862
Frank Blanchard
b. Apr 1870
12
Minna Blanchard
[1.1.4.1.3.3.4.6.4.4.5.1]
b. Aug 1885
12
Amber Lucy Blanchard
[1.1.4.1.3.3.4.6.4.4.5.2]
b. Jul 1889
12
Sadie Blanchard
[1.1.4.1.3.3.4.6.4.4.5.3]
b. Jun 1891
12
Frank Blanchard
[1.1.4.1.3.3.4.6.4.4.5.4]
b. 13 Jan 1893 d. 26 Sep 1975 [
=>
]
12
John Blanchard
[1.1.4.1.3.3.4.6.4.4.5.5]
b. Jan 1896
12
Lena Blanchard
[1.1.4.1.3.3.4.6.4.4.5.6]
b. Mar 1897
12
Earl Blanchard
[1.1.4.1.3.3.4.6.4.4.5.7]
b. 11 Nov 1899 d. 5 Mar 1989
12
Catherine M Blanchard
[1.1.4.1.3.3.4.6.4.4.5.8]
b. 1907
11
Vina Sawyer
[1.1.4.1.3.3.4.6.4.4.6]
b. 1864
11
Frederick W Sawyer
[1.1.4.1.3.3.4.6.4.4.7]
b. 1865
11
Tim Sawyer
[1.1.4.1.3.3.4.6.4.4.8]
b. 1867
11
Simeon F Sawyer
[1.1.4.1.3.3.4.6.4.4.9]
b. 1868
11
Andrew J Sawyer
[1.1.4.1.3.3.4.6.4.4.10]
b. 1869 d. 7 Oct 1935
11
Nancy J Sawyer
[1.1.4.1.3.3.4.6.4.4.11]
b. 1871
11
Jennie Sawyer
[1.1.4.1.3.3.4.6.4.4.12]
b. 1872
11
Jasper Sawyer
[1.1.4.1.3.3.4.6.4.4.13]
b. 1874
9
Lydia Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.5]
b. 1777
9
Martha Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.6]
b. 1781
9
Clarissa Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.7]
b. 11 Mar 1784
Joel Sawyer, Jr
b. 7 Aug 1781 d. 1 Sep 1859
10
Joel W Sawyer
[1.1.4.1.3.3.4.6.7.1]
b. 6 Dec 1815 d. 25 Dec 1908
+
Sarah Ann Moore
b. Abt 1818
+
Saphronie Simmons
b. Abt 1819
9
Henry Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.8]
b. Abt 1785 d. Aft 1800
9
Thomas Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.9]
b. 1787 d. 18 Sep 1887
Cynthia Allen
b. 3 Feb 1788 d. 30 Oct 1861
10
Allen G Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.9.1]
b. 1812 d. Aft 8 Jun 1880
Lydia Cranston
b. 1801 d. 1879
11
Sarah Malvinia Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.9.1.1]
b. 1837
Benjamin Lewis Crosby
b. 22 Jul 1847
12
Addie Lucinda Crosby
[1.1.4.1.3.3.4.6.9.1.1.1]
b. 1871 [
=>
]
12
Arthur Crosby
[1.1.4.1.3.3.4.6.9.1.1.2]
b. 1872 d. 1880
12
Iva Crosby
[1.1.4.1.3.3.4.6.9.1.1.3]
b. 1876
12
Samuel Morrison Crosby
[1.1.4.1.3.3.4.6.9.1.1.4]
b. 21 Sep 1878 [
=>
]
12
Mima Crosby
[1.1.4.1.3.3.4.6.9.1.1.5]
b. Abt 1879 d. 1946 [
=>
]
11
Samuel C Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.9.1.2]
b. 1840
10
Thomas Corbin Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.9.2]
b. 28 Mar 1814 d. 9 Feb 1892
Maria Winner
b. 18 Mar 1811 d. 24 Aug 1891
11
John H Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.9.2.1]
b. 18 Feb 1841 d. Jun 1917
10
Ruth Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.9.3]
b. Abt 1816
10
Abigail Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.9.4]
b. Abt 1818
10
Ira Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.6.9.5]
b. 2 Jan 1820 d. 7 Oct 1895
8
Anna Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.7]
b. 17 Feb 1744 d. 1811
Robert Follett
b. 27 Apr 1739 d. 9 Apr 1810
9
Robert Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.1]
b. 15 Sep 1764
Molly Knap
b. 17 Apr 1766
10
Nancy Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.1.1]
b. Aft 1800
9
Anna Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.2]
b. 22 Mar 1766 d. 23 Apr 1839
Joseph Ford
b. 29 Feb 1768 d. 30 Jan 1846
10
Sarah Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.1]
b. 1793 d. 1842
Nathan Neal
b. 1790
11
Mary Neal
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.1.1]
b. 1813
11
Joseph Neal
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.1.2]
b. 1814
11
Anna Neal
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.1.3]
b. 13 May 1816
Allen Wentworth
b. 7 Oct 1814 d. 11 Mar 1904
12
Abigail Amanda Wentworth
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.1.3.1]
b. 11 Feb 1836 d. 18 Mar 1865 [
=>
]
12
Edward Joseph Wentworth
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.1.3.2]
b. 8 Oct 1837 d. 4 Apr 1863
12
Alice Augusta Wentworth
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.1.3.3]
b. 11 Dec 1843 d. 12 Oct 1867
11
Perley Neal
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.1.4]
b. 1817
11
Fannie Neal
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.1.5]
b. 1818
11
Orrin S Neal
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.1.6]
b. 4 Nov 1819 d. 17 Jan 1903
Elsie E Smith
b. 29 Jan 1828 d. 17 Apr 1911
12
Joseph A Neal
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.1.6.1]
b. 1852
12
Daniel D Neal
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.1.6.2]
b. 12 Jan 1854 d. 15 Nov 1917 [
=>
]
12
Lewis R Neal
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.1.6.3]
b. Jun 1858 d. 25 Feb 1928 [
=>
]
12
Adrian Adelbert Neal
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.1.6.4]
b. 29 Jan 1869 d. 16 Jan 1940 [
=>
]
11
George Neal
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.1.7]
b. 1822
11
Sally Neal
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.1.8]
b. 1825
10
John Perley Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2]
b. 6 Dec 1794 d. 18 Sep 1869
Susanna Catharine Gallman
b. 10 Jul 1803 d. 1862
11
George Washington Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.1]
b. Abt 1813 d. 2 Jan 1913
Mary Ann Richie
b. Abt 1805 d. 24 Mar 1864
12
Robert Joseph Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.1.1]
b. 12 Nov 1830 d. 24 Jan 1899 [
=>
]
12
Catherine Jane Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.1.2]
b. 31 May 1831 d. 18 May 1869 [
=>
]
12
Cynthia Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.1.3]
b. 1833
12
Louisa Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.1.4]
b. 4 May 1835 d. 20 Feb 1901 [
=>
]
12
Phila Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.1.5]
b. 1836
12
George Washington Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.1.6]
b. 14 Aug 1842 d. 15 Aug 1877 [
=>
]
12
Lucina Elizabeth Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.1.7]
b. 7 Apr 1846 d. 11 Nov 1884 [
=>
]
12
Samuel S Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.1.8]
b. 1847 [
=>
]
12
Archelaus Tilly Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.1.9]
b. 14 May 1856 d. 20 Mar 1919 [
=>
]
12
Edna Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.1.10]
b. 14 Nov 1857
12
Jesse Franklin Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.1.11]
b. 10 Mar 1859 d. 1932
12
David Cicero Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.1.12]
b. 14 Sep 1861 d. Aug 1902 [
=>
]
Nancy Ann Anderson
b. 19 Oct 1844 d. 10 Sep 1913
12
Sarah Albino Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.1.13]
b. 2 Oct 1866 d. 18 May 1951 [
=>
]
12
Joseph Perley Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.1.14]
b. 18 Jan 1868 d. 1938 [
=>
]
12
William Erastus Acker Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.1.15]
b. 1 Feb 1870 d. 26 Apr 1936
12
Thomas Noah Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.1.16]
b. 3 Apr 1872 d. 28 Jan 1959
12
Daughter Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.1.17]
b. 1873 d. 1874
12
George Madison Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.1.18]
b. 22 Oct 1874 d. 4 Oct 1953
12
Florence E Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.1.19]
b. 28 Jan 1879 d. Feb 1972 [
=>
]
12
Alvin Elmer Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.1.20]
b. 2 Nov 1882 d. 15 Nov 1966 [
=>
]
11
Joseph Perley Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.2]
b. 25 Jun 1826 d. 1855
Mary Garrett
b. 1830
12
Otis Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.2.1]
b. 1850
12
Myrtle Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.2.2]
b. 1852
11
Jesse Stanley Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.3]
b. 1828
Sarah Farmer
b. 16 Jun 1833 d. 10 Aug 1905
12
Susannah K Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.3.1]
b. 16 Jun 1852 d. 29 Jan 1941
12
James W Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.3.2]
b. 31 Dec 1861 d. 24 Jan 1956
11
John Gallman Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.4]
b. 9 Sep 1829 d. 1 Jan 1883
Arminda Tilly Adeline Hays
b. 1824 d. Jul 1862
12
Chloe Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.4.1]
b. 3 Sep 1853 d. 20 Sep 1943 [
=>
]
12
Sarah E Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.4.2]
b. 10 Nov 1855 d. 23 Mar 1939 [
=>
]
12
James P Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.4.3]
b. 29 Dec 1857 [
=>
]
12
Stanley T Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.4.4]
b. 1 Mar 1861 d. 1865
Sarah Oaks
b. 7 Nov 1838 d. 27 Jan 1885
12
William Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.4.5]
b. Abt 1871 d. 23 Sep 1936 [
=>
]
12
Isabel Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.4.6]
b. 5 Mar 1872 d. 7 Jun 1976
12
Amanda Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.4.7]
b. 24 Sep 1874 d. 10 Sep 1956 [
=>
]
12
Arminda E Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.4.8]
b. 29 May 1876 d. 1 Aug 1981 [
=>
]
12
Jesse E Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.4.9]
b. 1 Apr 1878 d. 17 Nov 1938
11
Sarah Ann Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.5]
b. 10 May 1831 d. 28 Nov 1920
William Cicero Denson
b. 20 Oct 1826 d. 10 Jan 1906
12
William Archelaus Perley Denson
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.5.1]
b. 26 Jun 1849 d. 4 Oct 1873
12
John Hilliard Denson
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.5.2]
b. 19 Oct 1850 d. 1 May 1875 [
=>
]
12
James Washington Denson
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.5.3]
b. 7 Apr 1853 d. 4 Feb 1923 [
=>
]
12
Frances Ann Denson
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.5.4]
b. 26 Oct 1855 d. 20 Nov 1855
12
Thomas Cicero Denson
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.5.5]
b. 11 Mar 1857 d. 28 Feb 1935 [
=>
]
12
Clayburne Stanley Denson
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.5.6]
b. 7 Sep 1859 d. 17 Apr 1950 [
=>
]
12
Ezra Dailey Denson
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.5.7]
b. 5 Oct 1861 d. 12 Jan 1944 [
=>
]
12
George Mathers Denson
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.5.8]
b. 10 Dec 1867 d. 15 Sep 1946 [
=>
]
12
Martha Emma Denson
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.5.9]
b. 18 May 1869 d. 29 Nov 1869
12
Rebecca Dora Denson
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.5.10]
b. 14 Dec 1870 d. 8 Mar 1962
12
Sarah Genettie Catherine Denson
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.5.11]
b. 5 Jun 1873
12
Daughter Denson
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.5.12]
b. 27 Sep 1875 d. 27 Sep 1875
11
Susan K Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.6]
b. 25 Oct 1835 d. 22 Oct 1836
11
Thomas Cellars Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.7]
b. 1 Aug 1838 d. 7 Sep 1921
Martha Ellender McKee
b. 15 Jul 1836 d. 21 Oct 1919
12
John Perley Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.7.1]
b. 27 May 1861 d. 11 Mar 1954 [
=>
]
12
William C Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.7.2]
b. 9 Jul 1862 d. 16 Nov 1895 [
=>
]
12
David D Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.7.3]
b. 14 Sep 1864 d. 28 Feb 1886
12
Mary G Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.7.4]
b. 7 Mar 1866
12
George T Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.7.5]
b. Oct 1870 d. Aug 1956 [
=>
]
12
Jesse S Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.7.6]
b. 7 May 1872 d. 27 Feb 1895 [
=>
]
12
Sarah Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.7.7]
b. 1874 d. Dec 1876
12
James M Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.7.8]
b. 11 Jan 1878 d. 31 Dec 1886
12
Benjamin Franklin Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.7.9]
b. Oct 1889 d. 17 Dec 1945 [
=>
]
11
David Daly Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.8]
b. 18 Nov 1840 d. 17 Jan 1923
Sarah E Ritchie
b. 18 Oct 1849 d. 21 Jun 1910
12
Therosie Estelle Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.8.1]
b. Mar 1870 [
=>
]
12
Alfred Pierre Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.8.2]
b. 9 Feb 1872 d. 27 Dec 1958 [
=>
]
12
Son Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.8.3]
b. 5 Mar 1874 d. 8 Mar 1874
12
William Franklin Walter Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.8.4]
b. 5 Mar 1874 d. 23 Feb 1969 [
=>
]
12
Katrina E Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.8.5]
b. 25 Mar 1876 d. 1 Oct 1877
12
Melissa C Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.8.6]
b. 25 Mar 1876 [
=>
]
12
Silas T Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.8.7]
b. 17 Mar 1880 d. 17 May 1956 [
=>
]
12
Nancy Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.8.8]
b. 17 Apr 1880 d. 21 Apr 1942
12
George Elbert Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.8.9]
b. 27 Aug 1884 d. 5 Mar 1964 [
=>
]
12
Thomas Jesse Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.8.10]
b. 16 Jan 1887 d. 28 Apr 1958 [
=>
]
11
William Follett Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.2.9]
b. 28 Feb 1843 d. 28 Aug 1862
10
Anna Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.3]
b. 1796
10
Mary Ophria Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.4]
b. 1798
10
Joseph Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.5]
b. 12 May 1800 d. 26 Sep 1882
Olive Lindsay
b. 17 Dec 1806 d. 4 Oct 1881
11
Electa Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.5.1]
b. Abt 1827 d. 15 Jun 1854
Chandler Ballard
b. 26 Aug 1826 d. 25 Mar 1861
12
Alice Ballard
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.5.1.1]
b. 8 May 1851
12
Edith Ballard
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.5.1.2]
b. 1853 d. Bef 25 Mar 1861
11
Orville Davencourt Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.5.2]
b. 28 Aug 1829 d. 9 May 1909
Orille Aurilla Day
b. 22 Oct 1829 d. 1917
12
Edwin L Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.5.2.1]
b. 1 May 1851 d. 3 Jun 1908 [
=>
]
12
Addie M Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.5.2.2]
b. 14 Oct 1862
11
Ortan Davencourt Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.5.3]
b. 19 Mar 1833 d. 14 Jan 1908
+
Clarissa Hutchins
b. 1833 d. 1857
Finette Hanahan
b. 1838 d. Mar 1862
12
Clara A Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.5.3.1]
b. 2 May 1861 d. 13 Feb 1931 [
=>
]
Adelia A Pierce
b. Apr 1842 d. 3 Jun 1914
12
Mary Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.5.3.2]
b. 13 Apr 1865 d. 23 May 1929
11
Devillo C Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.5.4]
b. 2 Apr 1835 d. 1 May 1862
11
Annette I Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.5.5]
b. 1838
11
Adelia Minerva Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.5.6]
b. 21 May 1843 d. 4 Apr 1927
Lewis Barbour Mathews
b. 8 Oct 1832 d. 29 Oct 1892
12
Mary Ermina Mathews
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.5.6.1]
b. 9 Dec 1863 d. 26 Dec 1935 [
=>
]
12
Adelia Eliza Mathews
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.5.6.2]
b. 6 Nov 1865 d. 11 Jul 1936 [
=>
]
12
Lindsay Lewis Mathews
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.5.6.3]
b. 14 Feb 1869 d. 23 Jun 1934
12
Etta Mae Mathews
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.5.6.4]
b. 13 Jun 1871 d. 16 Nov 1943 [
=>
]
12
Grace Edna Mathews
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.5.6.5]
b. 15 Nov 1873 d. 4 Jan 1957 [
=>
]
12
Achsah Olive Mathews
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.5.6.6]
b. 6 Aug 1877 d. 27 Mar 1955
12
Max Devillo Mathews
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.5.6.7]
b. 20 Jun 1880 d. 27 Mar 1955 [
=>
]
12
Grover Cleveland Mathews
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.5.6.8]
b. 25 Dec 1883 d. 25 Sep 1968
12
Katherine Adams Mathews
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.5.6.9]
b. 2 May 1887 d. 20 Dec 1977
11
Achsah Amelia Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.5.7]
b. 29 May 1846 d. 26 Jun 1924
Wesley Kinney
b. 15 Dec 1837 d. 17 Mar 1926
12
Maude Kinney
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.5.7.1]
b. 8 Feb 1870 [
=>
]
12
Alvin C Kinney
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.5.7.2]
b. 5 Aug 1873 d. 1900
12
Kenneth Ford Kinney
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.5.7.3]
b. 23 May 1883 d. Dec 1967
10
Chloe Ford
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.6]
b. 1803
Francis L Drake
b. Abt 1800
11
Mayville Deforest Drake
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.6.1]
b. 1839 d. 1910
Julia Ann Woodruff
b. Abt 1850 d. 25 Apr 1914
12
George John Drake
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.6.1.1]
b. May 1870 d. 11 Dec 1946
12
Rose Drake
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.6.1.2]
b. Abt 1872 [
=>
]
12
Irene Drake
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.6.1.3]
b. 22 Jan 1874 d. 13 Dec 1967 [
=>
]
12
William Henry Drake
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.6.1.4]
b. 1875
12
Celestia Drake
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.6.1.5]
b. 1878
12
Bertha Drake
[1.1.4.1.3.3.4.7.2.6.1.6]
b. 19 Mar 1885 [
=>
]
9
Mary Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.3]
b. 10 Oct 1767 d. Bef 1810
9
Abigail Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.4]
b. 18 Feb 1770
John Delong
b. Abt 1768
10
Eunice Delong
[1.1.4.1.3.3.4.7.4.1]
b. 2 Dec 1796 d. 20 Feb 1884
9
Calvin Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.5]
b. 6 Jan 1772 d. 21 Dec 1856
Drusilla Kempton
b. Abt 1787 d. 8 Apr 1856
10
William Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.5.1]
b. 18 Dec 1801
+
Fanny Pierce
b. 7 Jan 1803
10
Benjamin Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.5.2]
b. 22 Oct 1803 d. 11 Dec 1892
Hannah M Warren
b. 16 Jan 1813 d. 18 Jun 1900
11
Edwin Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.5.2.1]
b. Abt 1829
11
N Ellen Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.5.2.2]
b. Abt 1830
11
Hannah Ellen Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.5.2.3]
b. 3 Feb 1830
10
Ephraim Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.5.3]
b. 24 Dec 1805 d. 1 May 1864
Diana Higgins
b. 18 Mar 1806 d. 30 May 1886
11
Ephraim E Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.5.3.1]
b. 1835 d. 23 Nov 1911
Violette Messinger
b. 24 Mar 1842 d. 3 Mar 1916
12
Emily Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.5.3.1.1]
b. 26 Mar 1863 [
=>
]
12
Ellen Follette
[1.1.4.1.3.3.4.7.5.3.1.2]
b. 27 Nov 1864 d. 30 Oct 1871
12
Marvin J Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.5.3.1.3]
b. 19 Jun 1867 d. 14 Dec 1943
12
Irving Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.5.3.1.4]
b. 14 Apr 1869
11
Edward Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.5.3.2]
b. Abt 1836
11
Willard Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.5.3.3]
b. 1838 d. 1 Dec 1917
11
Oliver Stowell Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.5.3.4]
b. Abt 1849
11
Emily Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.5.3.5]
b. 26 Mar 1863
Will H Wood
b. Oct 1859
12
Gaila B Wood
[1.1.4.1.3.3.4.7.5.3.5.1]
b. Aug 1884 d. 23 Jun 1908
12
Fredrick K Wood
[1.1.4.1.3.3.4.7.5.3.5.2]
b. Feb 1887
12
James B Wood
[1.1.4.1.3.3.4.7.5.3.5.3]
b. May 1891
12
Beth E Wood
[1.1.4.1.3.3.4.7.5.3.5.4]
b. May 1893
11
William Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.5.3.6]
b. 16 Aug 1841
+
Anna Augusta Ives
b. 12 Sep 1849 d. 7 Nov 1911
10
Calvin Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.5.4]
b. 1807
Samantha
b. 1823
11
Ellen Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.5.4.1]
b. Abt 1850
11
Eugene W Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.5.4.2]
b. Oct 1851 d. 6 Apr 1906
Eliza Catherine Howard
b. 1856 d. 25 Mar 1894
12
Cora Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.5.4.2.1]
b. Abt 1879
12
Symantha Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.5.4.2.2]
b. 1881
12
Agnes Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.5.4.2.3]
b. 1883
12
Adelbert Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.5.4.2.4]
b. May 1887 d. 13 Nov 1956
12
Catherine Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.5.4.2.5]
b. 1889
11
Edwin B Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.5.4.3]
b. Jan 1855
Anna W Fry
b. Jun 1859
12
Frederick M Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.5.4.3.1]
b. 24 Jul 1879
10
Anna Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.5.5]
b. 1809 d. 24 Aug 1832
10
Daughter Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.5.6]
b. 1810
10
Daughter Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.5.7]
b. 1813
10
Hiram Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.5.8]
b. 1 Nov 1816 d. 20 Jan 1892
Emily Ames
b. 10 Jul 1818 d. 14 Oct 1885
11
Maria Louisa Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.5.8.1]
b. 8 Feb 1847 d. 17 Nov 1866
11
Anna A Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.5.8.2]
b. 18 May 1849 d. 15 Apr 1936
Caleb Cranson Jennings
b. 20 Jul 1845 d. 28 Jan 1927
12
Myrta Pauline Jennings
[1.1.4.1.3.3.4.7.5.8.2.1]
b. 17 Aug 1878 d. 29 Aug 1960 [
=>
]
12
Emogene Beatrice Jennings
[1.1.4.1.3.3.4.7.5.8.2.2]
b. 20 Jul 1880 d. 23 Apr 1922 [
=>
]
12
Edna Jennings
[1.1.4.1.3.3.4.7.5.8.2.3]
b. 9 Jul 1882 d. 4 Jul 1972 [
=>
]
11
Edgar Ames Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.5.8.3]
b. 19 Dec 1857 d. 24 Jul 1924
10
Louisa Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.5.9]
b. 1819
10
Calvin Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.5.10]
b. 1822
10
Mary Jane Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.5.11]
b. 1825
Isaac Maldron
b. Abt 1821
11
Saprillet Maldron
[1.1.4.1.3.3.4.7.5.11.1]
b. Abt 1851
11
Falconer Maldron
[1.1.4.1.3.3.4.7.5.11.2]
b. Abt 1854
11
Purley Maldron
[1.1.4.1.3.3.4.7.5.11.3]
b. Abt 1856
11
Hanley Maldron
[1.1.4.1.3.3.4.7.5.11.4]
b. Abt 1858
10
Fanny Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.5.12]
b. 1831 d. 11 Mar 1832
9
Elijah Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6]
b. 29 Mar 1775 d. Jul 1816
Sabra Hill
b. 28 Apr 1779 d. 24 Apr 1842
10
John Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.1]
b. Abt 1799
+
Paulina
b. Abt 1813
10
Sarah "Sally" Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.2]
b. Abt 1803
Henry Robinson
b. 1800 d. Aug 1874
11
Thomas W Robinson
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.2.1]
b. 1830
11
George H Robinson
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.2.2]
b. 1834
11
James M Robinson
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.2.3]
b. Abt 1836
Mary A Ray
b. May 1838
12
William Robinson
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.2.3.1]
b. Abt 1859
12
James R Robinson
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.2.3.2]
b. Abt 1862
12
Charles Robinson
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.2.3.3]
b. Abt 1864
12
Martha "Mattie" Robinson
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.2.3.4]
b. 12 Apr 1867
12
Ida Robinson
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.2.3.5]
b. Abt 1870
12
Eugene Robinson
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.2.3.6]
b. Abt 1871
11
Mary Elizabeth Robinson
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.2.4]
b. 1843 d. 1913
John J Plunkett
b. 1842 d. 1911
12
Jonathan Commodore Plunkett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.2.4.1]
b. 1 May 1861 d. 31 Jul 1925 [
=>
]
12
Mary Alice Plunkett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.2.4.2]
b. 1866 d. 1936
12
Julia Ann Plunkett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.2.4.3]
b. 1868 d. 1938 [
=>
]
12
Soulden Plunkett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.2.4.4]
b. 10 Oct 1871 d. 6 Sep 1941
12
Ida Plunkett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.2.4.5]
b. 1874 d. 1884
12
Nina Plunkett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.2.4.6]
b. 1878 d. 1948
12
Leslie Plunkett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.2.4.7]
b. 1880 d. 1950
10
Samuel Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3]
b. 26 Dec 1803 d. 1885
Marinda Rockwell
b. 1804 d. 5 Mar 1867
11
Erastus Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.1]
b. 18 Mar 1827 d. 22 Mar 1886
Lurancy Mann
b. May 1811 d. 7 Jul 1891
12
Daughter Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.1.1]
b. 1830
12
Louisa Jane Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.1.2]
b. 19 Jun 1832
12
Ann Elizabeth Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.1.3]
b. 5 Nov 1834
12
William Mann Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.1.4]
b. 19 Sep 1836 [
=>
]
12
Mary A Follette
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.1.5]
b. 1838 d. 1844
12
Melvina C Follette
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.1.6]
b. 1840 d. 1841
12
Melissa E Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.1.7]
b. 1843 d. 1862
12
John Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.1.8]
b. 1845
12
Hamilton B Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.1.9]
b. 11 Dec 1846 d. 20 Mar 1893 [
=>
]
12
Orvis Marion Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.1.10]
b. 14 Dec 1847 d. 26 Jun 1938 [
=>
]
12
John Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.1.11]
b. 1850
12
Hector Tupper Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.1.12]
b. 10 Feb 1855 d. 31 Aug 1915 [
=>
]
12
Charles E Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.1.13]
b. Aug 1856 [
=>
]
11
David M Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.2]
b. 1828 d. 29 Nov 1889
Almira Goodrich
b. 23 Jan 1833 d. 18 Jan 1904
12
Edwin Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.2.1]
b. 3 Aug 1850 d. 27 Sep 1916 [
=>
]
12
Ervin A Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.2.2]
b. 1851
12
Haller H Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.2.3]
b. 1852 d. 20 Nov 1924
12
Ernest A Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.2.4]
b. 1853 d. 21 Apr 1923
12
Alexander Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.2.5]
b. 1855
12
Willis Andrew Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.2.6]
b. 22 Feb 1855 d. 13 Jul 1933
12
Charles B Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.2.7]
b. Apr 1857 d. 10 Oct 1918
12
Hallen Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.2.8]
b. 1859
12
William Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.2.9]
b. 1860
12
Ralph Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.2.10]
b. 17 Apr 1861 d. 17 Sep 1930 [
=>
]
Janet Morey
b. 1842
12
Max Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.2.11]
b. 1863
12
Anna M Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.2.12]
b. 1865
12
Malcolm Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.2.13]
b. 1866
11
Marchel Abraham Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.3]
b. 2 May 1830 d. 30 Jul 1907
Susan A Goodrich
b. 18 Feb 1828 d. 27 Aug 1918
12
William Spencer Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.3.1]
b. 16 Oct 1855 d. Aft 1927 [
=>
]
12
Emma Amelia Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.3.2]
b. 14 Aug 1857 d. 15 Nov 1921 [
=>
]
12
Frances Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.3.3]
b. 4 Jan 1860 d. 22 Oct 1933 [
=>
]
12
Ellen Follet
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.3.4]
b. 20 Dec 1861 [
=>
]
12
George A Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.3.5]
b. 1862 d. 30 Jan 1939
12
Harriett Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.3.6]
b. 16 Sep 1863 d. 26 Mar 1864
12
Henry P Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.3.7]
b. 11 Dec 1865 d. Aft 1928
12
Ellen M Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.3.8]
b. Abt 1869
12
Frankie Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.3.9]
b. Abt 1871
12
William S Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.3.10]
b. Abt 1873
11
John D Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.4]
b. 1832 d. 1900
Carolina Genung
b. 1835
12
Daniel Grant Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.4.1]
b. 4 Mar 1865 d. 20 Feb 1957 [
=>
]
12
George H Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.4.2]
b. 28 Feb 1867 d. 10 Jan 1950
12
Elizabeth Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.4.3]
b. 1869
12
John Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.4.4]
b. 1871
12
Jay Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.4.5]
b. 1874
12
Della Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.4.6]
b. 1877
12
Merrit Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.4.7]
b. 1880 d. 1930
12
Anna M Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.4.8]
b. Apr 1883 d. 16 Jan 1955
12
Mary A Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.4.9]
b. May 1891 d. 16 Jan 1955
11
Harlow Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.5]
b. 15 Aug 1834 d. 2 Jul 1911
Rachael Goodrich
b. 10 Jun 1844 d. 30 May 1906
12
Jessie Adell Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.5.1]
b. 25 Jul 1862 d. 17 Nov 1940 [
=>
]
12
Adelbert Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.5.2]
b. 25 Feb 1866 d. 2 Apr 1867
12
Dudley James Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.5.3]
b. 8 Sep 1872 d. 21 Jun 1917 [
=>
]
12
Walter Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.5.4]
b. 7 May 1874 d. 17 Oct 1950 [
=>
]
12
Lillian Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.5.5]
b. 6 Jan 1876 d. 30 Apr 1896
12
Ora Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.5.6]
b. 21 Sep 1878 d. 1960
12
Lena Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.5.7]
b. 2 May 1886 d. 29 Nov 1953
11
Orville Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.6]
b. Abt 1834
11
Mary Jane Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.7]
b. 1839 d. 21 Apr 1862
11
Samuel Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.8]
b. 12 Apr 1840 d. 7 Apr 1917
Martha Pike
b. 13 Oct 1843
12
Mary Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.8.1]
b. 8 Jun 1862 d. 1 Apr 1864
12
Samuel K Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.8.2]
b. 7 Aug 1864 d. 12 May 1878
12
Nelson W Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.8.3]
b. 1 Nov 1866 d. 18 Nov 1936
12
Hurbert Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.8.4]
b. 27 Feb 1867 d. 23 Apr 1941
12
Clark E Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.8.5]
b. 23 Aug 1870 d. 30 Jan 1901
12
Floyd Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.8.6]
b. 19 Nov 1875 d. 1948
12
Flora Martha Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.8.7]
b. 29 Dec 1883 d. 1 Jun 1974
11
Mary Ann Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.9]
b. Abt 1841
11
Orren Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.10]
b. Feb 1842 d. 26 Jul 1907
11
George W Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.11]
b. 29 Mar 1845 d. 9 Jul 1926
Mary Elizabeth Guile
b. 22 Sep 1840 d. 21 Mar 1883
12
Julia Merinda Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.11.1]
b. 3 Sep 1867 d. 19 Dec 1935
12
George Clinton Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.11.2]
b. 28 Dec 1871 d. 10 Aug 1938
12
Whitman Abram Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.11.3]
b. Jan 1873 d. 25 Mar 1938 [
=>
]
12
Frank Dewitt Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.11.4]
b. 8 Jun 1883 d. 20 Sep 1957
11
Willard Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.12]
b. 27 Jul 1847 d. 14 Sep 1916
Helen Holdredge
b. 29 Aug 1847 d. 12 May 1921
12
Frederick D Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.12.1]
b. 10 Dec 1870 d. 29 Oct 1938
12
Addie W Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.3.12.2]
b. 5 Feb 1878 d. 9 Apr 1941
10
Orpha Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.4]
b. Abt 1805
+
John Harrington
b. 9 Jun 1803
10
Daniel Edward Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.5]
b. 11 Nov 1807 d. 27 Nov 1901
Catherine Jane Longyear
b. 27 Apr 1814 d. 15 Jun 1886
11
Emmerson Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.5.1]
b. Sep 1835
Mary A King
b. 1 Jun 1839 d. 12 Aug 1866
12
Frances Margaret Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.5.1.1]
b. Nov 1863 d. 1910 [
=>
]
12
James E Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.5.1.2]
b. 14 May 1866 d. 3 Aug 1866
Mariah Bristow
b. 1848 d. 28 Mar 1891
12
Mary Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.5.1.3]
b. 20 Feb 1870 d. 19 Jul 1880
12
Rosella Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.5.1.4]
b. 15 Feb 1879 d. 24 Jul 1879
12
Eva Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.5.1.5]
b. 16 Aug 1880
12
William Adam Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.5.1.6]
b. 18 Oct 1882 d. 7 Feb 1901
12
Lulu Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.5.1.7]
b. 18 Oct 1883 d. 5 Jul 1884
12
Richard Alphonso Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.5.1.8]
b. 21 Dec 1889 d. Mar 1991
11
Mary Jane Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.5.2]
b. 12 Feb 1837 d. 15 Jan 1915
Samuel Hepburn Maxwell
b. 20 Jul 1826 d. 24 Apr 1899
12
Josephine Maxwell
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.5.2.1]
b. Abt 1854
12
Harry Stoddard Maxwell
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.5.2.2]
b. Abt 1857 d. 15 Nov 1930 [
=>
]
12
Rolla Maxwell
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.5.2.3]
b. 2 Nov 1859 d. 27 Mar 1913 [
=>
]
12
Charles Calvin Maxwell
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.5.2.4]
b. 1862 d. 1931
12
William Hepburn Maxwell
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.5.2.5]
b. 1 Feb 1868 d. 14 Jul 1941 [
=>
]
12
Kate Maxwell
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.5.2.6]
b. Abt 1864
12
Fred Maxwell
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.5.2.7]
b. Abt 1870
12
Richard Maxwell
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.5.2.8]
b. Abt 1872
11
Daughter Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.5.3]
b. 1839
11
Calvin Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.5.4]
b. Nov 1843
Eliza Spray
b. 1847
12
Charles Calvin Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.5.4.1]
b. Dec 1867 [
=>
]
12
Albert Houston Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.5.4.2]
b. 1870 [
=>
]
12
Ida M Follet
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.5.4.3]
b. 1873 d. 1873
12
Marquis de Lafeyette Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.5.4.4]
b. Aug 1875 [
=>
]
12
James Archibald Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.5.4.5]
b. 29 Aug 1876 d. 24 Jun 1955
12
Coleman Moss Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.5.4.6]
b. 1 Sep 1878 d. 22 Mar 1943
12
Bertha C Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.5.4.7]
b. 13 Oct 1884
11
Sarah Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.5.5]
b. 1844
11
James Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.5.6]
b. 1845
11
Daniel Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.5.7]
b. 1846
11
Charles Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.5.8]
b. 1849
11
Frances Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.5.9]
b. 1851
11
Lurancy Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.5.10]
b. Abt 1852
George Mason Duncan
b. 1853
12
Daniel Henry Duncan
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.5.10.1]
b. 4 Oct 1877
10
Eunice Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.6]
b. Abt 1809
+
John Harrington
10
Ann Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.7]
b. Abt 1811
+
John Orr
10
Elsie Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.8]
b. 1811
10
Joseph Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.9]
b. 17 Jun 1814 d. 1897
Cynthia Stiles
b. 3 Jan 1823 d. 2 Jun 1900
11
John D Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.9.1]
b. 30 Sep 1845 d. 5 Oct 1846
11
Sabra Ann Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.9.2]
b. 15 Sep 1847 d. 18 Sep 1908
Jacob Brewer
b. 21 Jun 1833 d. 24 May 1909
12
Jacob Albert Brewer
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.9.2.1]
b. 15 Jun 1865 d. 1 Jul 1925
12
Joseph Lewis Brewer
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.9.2.2]
b. 3 Aug 1867 d. 20 Jan 1942 [
=>
]
12
Charles Frederick Brewer
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.9.2.3]
b. 8 Sep 1869 d. 26 Oct 1887
12
Harriett Louisa Brewer
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.9.2.4]
b. 13 Mar 1872 d. 23 Mar 1964 [
=>
]
12
Adam Rufus Brewer
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.9.2.5]
b. 21 Feb 1874 d. 9 Feb 1957 [
=>
]
12
George Franklin Brewer
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.9.2.6]
b. 21 May 1876 d. 25 Apr 1877
12
John Hyrum Brewer
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.9.2.7]
b. 10 Feb 1878 d. 8 Feb 1950 [
=>
]
12
Emma Ann Brewer
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.9.2.8]
b. 3 Apr 1880 d. 27 Oct 1887
12
William Henry Brewer
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.9.2.9]
b. 24 Feb 1882 d. 20 Aug 1882
12
Cynthia Jane Brewer
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.9.2.10]
b. 8 Aug 1883 d. 23 Oct 1887
12
Alice May Brewer
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.9.2.11]
b. 11 Mar 1886 d. 6 Apr 1934
11
Cornelia Jane Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.9.3]
b. 25 Apr 1849 d. 12 Jul 1901
James T Wilson
b. 19 Sep 1835 d. 4 May 1912
12
Cynthia Jane Wilson
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.9.3.1]
b. 20 Jul 1869 d. 25 Mar 1958 [
=>
]
12
Mary Louise "Mame" Wilson
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.9.3.2]
b. 1871 d. 1944
12
Loretta Ann Wilson
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.9.3.3]
b. 6 Jan 1873 d. Sep 1954
12
Fannie Matilda Wilson
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.9.3.4]
b. Sep 1876 d. 1956 [
=>
]
12
Amelia Antoinette Wilson
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.9.3.5]
b. 19 Dec 1879 d. 7 Jan 1899
12
Joseph Franklin Wilson
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.9.3.6]
b. 1 Oct 1884 d. 3 Dec 1958
12
James Roy Wilson
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.9.3.7]
b. 30 May 1888 d. 10 Mar 1951 [
=>
]
11
Joseph Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.9.4]
b. 29 Aug 1850 d. 4 Oct 1909
11
Sarah Louisa Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.9.5]
b. 27 Oct 1851 d. 29 Mar 1863
11
Gerome M Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.9.6]
b. 24 Jul 1855 d. 18 May 1858
11
Henry Francis Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.9.7]
b. 12 May 1859 d. Nov 1927
11
Mary Elizabeth Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.6.9.8]
b. 29 Aug 1861 d. 27 Dec 1862
9
Samuel Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.7]
b. 2 Apr 1776
Rebecca
b. Abt 1778
10
Permelia Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.7.1]
b. Abt 1817
9
William Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.8]
b. 3 Mar 1778 d. 1853
Sybil Blackman
b. 1780 d. Bef 1850
10
Betsy Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.8.1]
b. 1808
10
Ann Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.8.2]
b. 1810
10
John Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.8.3]
b. 1813
Hannah
b. Abt 1815
11
Martin Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.8.3.1]
b. Bef 1850
10
William Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.8.4]
b. 1820
Hannah
b. Abt 1825
11
Frances E Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.8.4.1]
b. Abt 1857 d. 20 Oct 1899
10
Hannah Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.8.5]
b. 21 Feb 1824 d. 21 Oct 1898
10
Samuel B Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.8.6]
b. 6 Nov 1827 d. 13 Feb 1920
Almeda White
11
Charles S Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.8.6.1]
b. 4 Mar 1856 d. 20 Jan 1863
11
Edward W Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.8.6.2]
b. 23 Sep 1865 d. 26 Mar 1928
+
Esther Osborn
b. 1 Apr 1842 d. 21 Oct 1895
10
Henry Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.8.7]
b. 15 Oct 1829 d. 31 May 1905
9
Eunice Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.9]
b. 28 Mar 1779
Joseph Baker
b. Abt 1777
10
Joseph Baker, Jr
[1.1.4.1.3.3.4.7.9.1]
b. Abt 1799
10
John Baker
[1.1.4.1.3.3.4.7.9.2]
b. Abt 1801
10
Erastus Baker
[1.1.4.1.3.3.4.7.9.3]
b. Abt 1803
+
Loraney Mann
10
Norma Baker
[1.1.4.1.3.3.4.7.9.4]
b. Abt 1805
10
Maria Baker
[1.1.4.1.3.3.4.7.9.5]
b. 1809
John B Van Dyke
b. 9 Oct 1808 d. 30 Jul 1883
11
Richard W Van Dyke
[1.1.4.1.3.3.4.7.9.5.1]
b. 28 Feb 1836 d. 28 Mar 1864
+
Eliza Maria Preston
b. 23 Jun 1834 d. 14 Dec 1882
11
John Van Dyke
[1.1.4.1.3.3.4.7.9.5.2]
b. 6 Jan 1839
+
Nancy Jane "Jennie" Older
b. 20 Aug 1842 d. 25 Jul 1916
9
John Follett
[1.1.4.1.3.3.4.7.10]
b. 22 Aug 1783
+
Lydia Reed
b. 1785
8
Calvin Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.8]
b. 17 Aug 1745 d. 10 Nov 1762
8
Deborah Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.9]
b. 6 Aug 1747
8
Daniel Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10]
b. 7 Sep 1749 d. 1798
Deborah Hildreth
b. 5 May 1755 d. Abt 1789
9
Samuel Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.1]
b. 1777 d. Aft 1800
9
Daniel Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2]
b. 27 Aug 1779 d. 27 Sep 1839
Mary Tiffany
b. 17 Jun 1777 d. 12 Sep 1845
10
Cynthia Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.1]
b. 15 Jan 1805 d. 1889
Ezra Gray
b. 1793 d. 1870
11
Hiram T Gray
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.1.1]
b. 25 Aug 1832 d. 30 Jun 1875
+
Caroline R Lane
b. 1839 d. 1902
11
Daniel William Gray
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.1.2]
b. 19 May 1834 d. 9 Dec 1890
Eliza Jane Ostrander
b. Abt 1840 d. 29 Oct 1861
12
William Delvin Grey
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.1.2.1]
b. 27 Feb 1859 d. 11 Aug 1949
12
Frank Gray
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.1.2.2]
b. Abt 1861
Sarah Ann Smith
b. 19 Dec 1851 d. 15 Jan 1941
12
Jennie Gray
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.1.2.3]
b. 3 May 1870 d. 5 Oct 1941
12
Nellie F Gray
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.1.2.4]
b. 2 Jul 1871 d. Aug 1883
12
Frank N Gray
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.1.2.5]
b. 3 Nov 1873
12
Mary Ellen Gray
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.1.2.6]
b. 27 Aug 1877 d. 23 Feb 1953
12
Carrie M Gray
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.1.2.7]
b. 8 Dec 1881 d. 12 Sep 1949
11
Daughter Gray
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.1.3]
b. 1834
11
Emily Jane Gray
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.1.4]
b. 14 Nov 1837 d. 13 Feb 1908
11
Betsey T Gray
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.1.5]
b. 1840
11
Mary M Gray
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.1.6]
b. 1844
11
George W Gray
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.1.7]
b. 1846 d. 4 Aug 1918
Sidney
b. Jan 1846
12
Ramond G Gray
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.1.7.1]
b. Apr 1869
12
Minnie M Gray
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.1.7.2]
b. May 1872 [
=>
]
12
Floyd Gray
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.1.7.3]
b. Sep 1874
12
Daisey M Gray
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.1.7.4]
b. Jun 1881
10
Samuel Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.2]
b. 21 Dec 1808 d. 9 Jan 1887
Phoebe Kingsbury
b. 14 Dec 1812 d. 24 Apr 1851
11
Sabrina Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.2.1]
b. 30 Mar 1832 d. 1920
+
Scudder Todd
b. 1831 d. 1901
11
George T Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.2.2]
b. 4 Dec 1833 d. 28 Aug 1868
11
Polly Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.2.3]
b. 4 Jun 1835 d. 24 Mar 1855
11
Daniel Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.2.4]
b. 21 Jun 1837
11
Margaret Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.2.5]
b. 18 Jun 1839 d. 8 Oct 1840
11
Mason Kingsbury Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.2.6]
b. 17 Feb 1842 d. 27 Mar 1919
Olive Amanda Kingsbury
b. 10 Dec 1844 d. 1924
12
Nelson E Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.2.6.1]
b. 1867 d. 1943
12
Ina Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.2.6.2]
b. Sep 1869
12
George W Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.2.6.3]
b. Jan 1872
12
Pearl O Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.2.6.4]
b. Jun 1884
11
Samuel Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.2.7]
b. 4 Mar 1844 d. May 1924
11
Hassett Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.2.8]
b. 20 Feb 1846 d. 3 Jan 1852
11
Almira Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.2.9]
b. 21 Apr 1848 d. 22 Sep 1911
+
Franklin F King
b. 1845 d. 1898
11
Cynthia Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.2.10]
b. 10 Nov 1850 d. 17 Apr 1851
10
Almira Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.3]
b. 13 Jun 1810 d. 4 Feb 1889
George Tiffany
b. 4 May 1808 d. 21 Jun 1885
11
Cynthia Jane Tiffany
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.3.1]
b. 2 Feb 1830 d. 6 Oct 1845
11
Zenos Tiffany
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.3.2]
b. 21 Jul 1831 d. Dec 1843
11
Ira Patchen Tiffany
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.3.3]
b. 14 Feb 1835 d. 21 Mar 1905
Mary Ann Davis
b. 4 Oct 1843 d. 21 Jul 1885
12
Ira Davies Tiffany
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.3.3.1]
b. 24 Jul 1863 d. 27 Oct 1902
12
Zenos William Tiffany
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.3.3.2]
b. 21 Aug 1865 d. 14 Feb 1938
12
Sylvia Ann Tiffany
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.3.3.3]
b. 14 Nov 1867 d. 23 Dec 1936
12
Cynthia Jane Tiffany
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.3.3.4]
b. 27 Feb 1870 d. Bef 1877
12
Mary Elizabeth Tiffany
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.3.3.5]
b. 17 May 1871 d. 5 Nov 1887
12
Almira Tiffany
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.3.3.6]
b. 29 Dec 1873 d. 21 Sep 1887
12
Franklin Brayn Tiffany
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.3.3.7]
b. 29 Feb 1876 d. 4 Oct 1877
12
Eliza Tiffany
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.3.3.8]
b. 30 Jan 1878 d. 2 Jun 1957
12
George Hyrum Tiffany
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.3.3.9]
b. 17 Apr 1880 d. 18 Mar 1939
12
Albert Henry Tiffany
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.3.3.10]
b. 5 Nov 1882 d. 2 Dec 1956
12
Ray Tiffany
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.3.3.11]
b. 21 Jul 1884 d. 16 Oct 1885
+
Sarah Ann Jolley
b. 18 Dec 1837 d. 9 Jan 1919
11
Loyal Peck Tiffany
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.3.4]
b. 27 Jul 1837 d. 15 Feb 1903
+
Martha Holden
b. 28 Jan 1825 d. 3 May 1886
11
Mary Tiffany
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.3.5]
b. 18 Dec 1844 d. 14 Dec 1845
11
Almira Rebecca Tiffany
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.3.6]
b. 18 Aug 1847 d. 23 Nov 1914
Giles Bliss Holden
b. 8 May 1842 d. 20 May 1897
12
Almira Rebecca Holden
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.3.6.1]
b. 8 Aug 1865 d. 25 Aug 1865
12
Ruia Angeline Holden
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.3.6.2]
b. 21 Oct 1866 d. 4 Mar 1948
12
Giles Robert Holden
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.3.6.3]
b. 8 Dec 1868 d. Mar 1889
12
Cynthia Holden
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.3.6.4]
b. 10 Mar 1870 d. 10 Mar 1870
12
George Tiffany Holden
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.3.6.5]
b. 9 May 1872 d. 13 Apr 1934
12
Nellie May Holden
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.3.6.6]
b. 30 Dec 1875 d. 6 Nov 1935
12
Burrell Henry Holden
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.3.6.7]
b. 29 Jun 1877 d. 11 Mar 1881
12
Leroy Edwin Holden
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.3.6.8]
b. 21 Sep 1879 d. 12 Feb 1881
12
Ivy LeNore Holden
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.3.6.9]
b. 24 May 1882 d. 18 Aug 1958
12
Merle Dee Holden
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.3.6.10]
b. 10 Jul 1885 d. 12 Sep 1938
12
Verna Holden
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.3.6.11]
b. 18 Dec 1887 d. 18 Dec 1887
12
Vera Holden
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.3.6.12]
b. 18 Dec 1887 d. 12 Feb 1967 [
=>
]
11
George Mason Tiffany
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.3.7]
b. 31 Jan 1850 d. 14 Mar 1909
Sarah Jane York
b. 18 Feb 1857 d. 27 Dec 1940
12
Mary Ellen Tiffany
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.3.7.1]
b. 22 Aug 1874 d. 18 Jun 1958
12
Sarah Jane Tiffany
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.3.7.2]
b. 16 Apr 1876 d. 23 Apr 1883
12
George Mason Tiffany
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.3.7.3]
b. 17 Nov 1877 d. 21 Apr 1883
12
Asa York Tiffany
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.3.7.4]
b. 24 Feb 1881 d. 3 Feb 1947
12
Lea Tiffany
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.3.7.5]
b. 7 May 1883 d. 7 Jan 1961
12
Ira George Tiffany
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.3.7.6]
b. 7 May 1883 d. 7 Jan 1961
12
Nelson Tiffany
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.3.7.7]
b. 4 Aug 1885 d. 27 Mar 1943
12
Almira Tiffany
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.3.7.8]
b. 16 Sep 1888 d. 26 Jul 1966
12
Ruia Tiffany
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.3.7.9]
b. 27 Nov 1890 d. 15 May 1965
12
Lenore Henrietta Tiffany
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.3.7.10]
b. 9 Aug 1893 d. 11 Sep 1967
11
Nelson Whipple Tiffany
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.3.8]
b. 6 Aug 1852 d. 20 Jan 1927
Nancy Medora Beesley
b. 8 Sep 1862 d. 15 May 1924
12
Nelson Whipple Tiffany
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.3.8.1]
b. 11 Sep 1880 d. 20 Nov 1904
12
Florence Tiffany
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.3.8.2]
b. 27 Apr 1882 d. 22 May 1964
12
Alathea Tiffany
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.3.8.3]
b. 28 Aug 1884 d. 3 Jan 1897
12
Ida May Tiffany
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.3.8.4]
b. 15 Nov 1888 d. 9 May 1968
12
George Milton Tiffany
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.3.8.5]
b. 8 May 1892 d. 25 May 1963
12
Martha Elva Tiffany
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.3.8.6]
b. 1 Aug 1898 d. 25 Nov 1989
12
Viola Tiffany
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.3.8.7]
b. 5 Jul 1903 d. 19 Jun 1969
10
Phoebe Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.4]
b. 13 Aug 1813 d. 18 Nov 1846
Benjamin Bengraw Shaw
b. 1808
11
Clymenia Azuba Shaw
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.4.1]
b. 2 Feb 1834 d. 10 Aug 1920
David Evans
b. 27 Oct 1804 d. 23 Jun 1883
12
Phebe Jane Evans
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.4.1.1]
b. 1 Dec 1855 d. 18 Dec 1855
12
James Evans
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.4.1.2]
b. 16 Aug 1857 d. 15 Apr 1940 [
=>
]
12
Edwin Thomas Evans
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.4.1.3]
b. 2 Feb 1860 d. 4 Mar 1946 [
=>
]
Benjamin Gibson
b. 9 May 1805 d. 26 Nov 1897
11
Hannah Gibson
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.4.2]
b. 24 Apr 1836 d. 31 Oct 1846
11
Isabella Amy Gibson
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.4.3]
b. 20 Mar 1838 d. 11 Feb 1898
William Coleman
b. 9 Dec 1836 d. 12 Feb 1910
12
William Coleman, Jr
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.4.3.1]
b. 3 Oct 1858 d. 19 Aug 1936 [
=>
]
12
Phebe Jane Coleman
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.4.3.2]
b. 20 May 1860 d. 11 Jun 1936 [
=>
]
12
Benjamin Leo Coleman
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.4.3.3]
b. 2 Sep 1862 d. 23 Jan 1937 [
=>
]
12
Amy Jane Coleman
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.4.3.4]
b. 13 May 1865 d. 19 Oct 1865
12
Mary Elizabeth Coleman
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.4.3.5]
b. 12 Apr 1866 d. 12 Dec 1869
12
John Coleman
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.4.3.6]
b. 6 Nov 1866 d. 24 Jul 1937 [
=>
]
12
Franklin Coleman
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.4.3.7]
b. 18 Mar 1868 d. 1 Jul 1917 [
=>
]
12
Hyrum Coleman
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.4.3.8]
b. 19 Aug 1868 d. 8 Oct 1947 [
=>
]
12
Prime Henry Coleman
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.4.3.9]
b. 24 Apr 1871 d. 30 Mar 1948
12
Sarah Francetta Coleman
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.4.3.10]
b. 20 Jun 1875 d. 9 May 1931 [
=>
]
12
Esther Coleman
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.4.3.11]
b. 8 Dec 1880 d. 1 Mar 1908 [
=>
]
11
Mary Jane Gibson
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.4.4]
b. 5 Feb 1840 d. 12 Jun 1912
Orson Kelsey
b. 1 Oct 1840 d. 7 May 1922
12
Mary Ellen Kelsey
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.4.4.1]
b. 22 Jan 1860 d. 28 Oct 1889 [
=>
]
12
Orson Kelsey, Jr
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.4.4.2]
b. 27 Aug 1861 d. 23 Mar 1904 [
=>
]
12
Benjamin Franklin Kelsey
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.4.4.3]
b. 6 Jun 1865 d. 28 Sep 1937 [
=>
]
12
Orin Kelsey
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.4.4.4]
b. 27 Sep 1866 d. 28 Sep 1866
12
George Albert Kelsey
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.4.4.5]
b. 6 Nov 1868 d. 10 Sep 1946
12
Theodore Kelsey
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.4.4.6]
b. 20 May 1871 d. 2 May 1963 [
=>
]
12
Abigail Kelsey
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.4.4.7]
b. 17 Feb 1873 d. 10 Dec 1956 [
=>
]
12
Easton Lemoine Kelsey
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.4.4.8]
b. 18 Oct 1875 d. 23 Jul 1963 [
=>
]
12
Amos C Kelsey
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.4.4.9]
b. 26 Jul 1876 d. 5 Sep 1956 [
=>
]
12
Rupert Lee Kelsey
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.4.4.10]
b. 8 Dec 1878 d. 12 Aug 1961 [
=>
]
12
Elmira Kelsey
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.4.4.11]
b. 10 Nov 1880 d. 19 Feb 1958 [
=>
]
12
Phoebe Jane Kelsey
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.4.4.12]
b. 23 Aug 1882 d. 16 Jul 1964 [
=>
]
11
Susan Jane Gibson
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.4.5]
b. 11 Oct 1842 d. 25 May 1929
John Franklin Sanders
b. 5 Mar 1830 d. 18 Mar 1896
12
Phebe Jane Sanders
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.4.5.1]
b. 23 Jan 1866 d. 9 May 1950 [
=>
]
12
Amanda Ann Sanders
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.4.5.2]
b. 14 Nov 1867 d. Aug 1868
12
Amy Elmira Sanders
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.4.5.3]
b. 8 Aug 1869 d. 25 Sep 1925
12
William Franklin Sanders
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.4.5.4]
b. 6 Jan 1872 d. 15 Nov 1906
12
Ellen Clymena Sanders
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.4.5.5]
b. 14 Jan 1874 d. 8 Oct 1953 [
=>
]
12
Joseph Myron Sanders
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.4.5.6]
b. 12 Mar 1876 d. 8 Jun 1944 [
=>
]
11
Jemima Gibson
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.4.6]
b. 1847
10
Carum Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.5]
b. 12 Aug 1815 d. 1843
10
Gerua Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.6]
b. 12 Aug 1815 d. 18 Sep 1848
10
Nelson Wheeler Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7]
b. 11 Jul 1818 d. 5 Jul 1887
Susan Jane Bailey
b. 9 Mar 1828 d. 5 Jun 1856
11
Son Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.1]
b. 15 Oct 1844 d. 15 Oct 1844
11
Miranda Jane Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.2]
b. 14 Mar 1847 d. 29 Dec 1907
+
John Williams
b. 8 Oct 1840 d. 21 May 1899
David R Barton
b. 1835
12
David Albert Barton
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.2.1]
b. 22 Jan 1865 d. 3 Sep 1930
12
Elizabeth M Barton
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.2.2]
b. Apr 1868 d. 15 Oct 1917 [
=>
]
12
Mary Ellen Barton
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.2.3]
b. 26 Jul 1870 d. 2 Feb 1926 [
=>
]
Henry Codd
b. 21 Aug 1836 d. 20 Jan 1911
12
Eliza Isabella Code
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.2.4]
b. 12 Nov 1873 d. 13 Mar 1911
12
Charles Levi Code
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.2.5]
b. 3 Apr 1876 d. 4 May 1954
12
Ruth Lorena Code
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.2.6]
b. 21 Apr 1880 d. 16 Nov 1939
12
Theda Maria Code
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.2.7]
b. 2 Jul 1883 d. 11 Jun 1932
11
Mary Janet Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.3]
b. 14 Feb 1849 d. Nov 1922
Charles Maynard
b. Abt 1849
12
Charles Maynard
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.3.1]
b. 1880
+
Richard Marlin Wadams
b. 4 Aug 1852 d. 11 Apr 1914
11
George Nelson Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.4]
b. 20 Mar 1851 d. 8 Jun 1912
Annie Baird
b. 5 Nov 1860 d. 1926
12
William Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.4.1]
b. Abt 1883 d. Abt 1888
12
Frank Henry Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.4.2]
b. 6 Dec 1885 d. 5 Sep 1946 [
=>
]
12
Edson George Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.4.3]
b. 25 Apr 1891 d. 4 Mar 1939
12
Ida Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.4.4]
b. Abt 1899 d. 4 Jun 1899
12
Mary Jannett Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.4.5]
b. 16 Apr 1900 d. 3 Aug 1900
12
Edith May Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.4.6]
b. 21 Nov 1903 d. 9 Oct 1945 [
=>
]
11
Edson Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.5]
b. 10 Oct 1853 d. 26 Feb 1909
Mary Ann Beck
b. 13 Jun 1865 d. 16 Jan 1937
12
Mary Magdaline Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.5.1]
b. 8 Oct 1881 d. 24 Feb 1964 [
=>
]
12
Susan Jane Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.5.2]
b. 17 Oct 1883 d. 25 Apr 1965 [
=>
]
12
William Edson Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.5.3]
b. 19 Oct 1885 d. 10 Mar 1976 [
=>
]
12
Luella Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.5.4]
b. 10 Jan 1888 d. 20 Feb 1924 [
=>
]
12
Amy Louisa Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.5.5]
b. 21 Sep 1890 d. 27 Mar 1972 [
=>
]
12
Delilah Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.5.6]
b. 16 Oct 1893 d. 25 Oct 1976 [
=>
]
12
Stanley Dean Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.5.7]
b. 13 Nov 1896 d. 25 Nov 1896
12
Leon Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.5.8]
b. 14 Jul 1899 d. 17 Jul 1966 [
=>
]
12
Vern George Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.5.9]
b. 10 Jan 1902 d. 9 May 1991
12
Kenneth Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.5.10]
b. 13 Jun 1904 d. 4 Apr 1973
11
Harriet Emily Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.6]
b. 21 Nov 1855 d. 4 Oct 1856
11
Annie Bard Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.7]
b. 5 Jun 1856
Susan Ann Gay
b. 13 Jun 1841 d. 29 Sep 1911
11
Martha Ellen Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.8]
b. 19 Jan 1858 d. 20 Oct 1937
Jacob Kesler
b. 30 Sep 1860 d. 25 Dec 1937
12
Hazel Gay Kesler
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.8.1]
b. 2 Apr 1884 d. 20 Dec 1956 [
=>
]
12
Essie Parthenia Kesler
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.8.2]
b. 23 Oct 1885 d. 29 Jul 1935
12
Frederick Nelson Kesler
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.8.3]
b. 22 Oct 1888 d. 13 Nov 1898
12
Dela Von Kesler
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.8.4]
b. 22 Feb 1890 d. 17 Jul 1934
12
Audrey Kesler
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.8.5]
b. 8 Jun 1893 d. 20 Apr 1897
12
Jacob Waldemar Kesler
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.8.6]
b. 23 Jan 1896 d. 8 Feb 1896
12
Martha Ellen Kesler
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.8.7]
b. 10 Sep 1897
11
Nelson Gay Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.9]
b. 21 Sep 1859 d. 2 Apr 1944
Susannah Wanless
b. 25 Apr 1866 d. 5 Jun 1949
12
William Nelson Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.9.1]
b. 22 Dec 1884 d. 30 May 1972 [
=>
]
12
John Gay Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.9.2]
b. 12 May 1887 d. 25 Jan 1949
12
James Anor Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.9.3]
b. 24 Feb 1889 d. 23 Jun 1946 [
=>
]
12
Raymond Leigh Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.9.4]
b. 17 May 1892 d. 9 Sep 1940
12
Marvian Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.9.5]
b. 11 Sep 1896 d. 26 Aug 1898
12
Frederick Dale Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.9.6]
b. 18 Mar 1908 d. 2 Oct 1960
11
Sylvia Gay Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.10]
b. 18 May 1862 d. 20 Jan 1940
Frederick Bateman Margetts
b. 9 Oct 1861 d. 7 Feb 1950
12
Fred Lynn Margetts
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.10.1]
b. 25 Sep 1885 d. 7 Jan 1971
12
Dora Estella Margetts
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.10.2]
b. 5 Mar 1887 d. 24 Jan 1963 [
=>
]
12
Paul Gay Margetts
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.10.3]
b. 12 Dec 1889 d. 6 Apr 1982 [
=>
]
12
Lucille Margetts
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.10.4]
b. 4 Mar 1893 d. 29 Oct 1959
12
Amy Jane Margetts
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.10.5]
b. 4 Oct 1895 d. 19 Feb 1952
12
Susan Ann Margetts
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.10.6]
b. 30 Mar 1898 d. 10 Oct 1995 [
=>
]
12
Anor Whipple Margetts
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.10.7]
b. 28 Feb 1900 d. 15 Apr 1969 [
=>
]
12
Nelson Whipple Margetts
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.10.8]
b. 2 Sep 1903 d. 20 Sep 1962 [
=>
]
11
Susan Ann Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.11]
b. 3 Nov 1864 d. 19 Dec 1935
Archer Walters Clayton
b. 10 Apr 1858 d. 27 Oct 1947
12
Archer Lynne Clayton
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.11.1]
b. 7 Jul 1883 d. 14 Oct 1952 [
=>
]
12
Don Carlos Clayton
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.11.2]
b. 15 Jan 1885 d. 14 Oct 1964 [
=>
]
12
Phyllis Clayton
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.11.3]
b. 29 Jun 1887 d. 13 Aug 1962 [
=>
]
12
Daughter Clayton
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.11.4]
b. 1889
12
Susan Ann Clayton
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.11.5]
b. 24 Dec 1891 d. 8 Jul 1977 [
=>
]
12
Alonzo Hyde Clayton
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.11.6]
b. 25 Apr 1893 d. 12 Apr 1984 [
=>
]
12
Ruth Clayton
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.11.7]
b. 16 Aug 1895 d. 12 May 1896
12
William Arthur Clayton
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.11.8]
b. 30 Aug 1897 d. 28 Jan 1980 [
=>
]
11
Alexander Samuel Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.12]
b. 2 Mar 1867 d. 8 Jan 1899
Sarah "Daisy" Van Natta
b. 8 May 1870 d. 18 Apr 1962
12
Mary Irene Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.12.1]
b. 16 Oct 1891 d. 5 Mar 1989 [
=>
]
12
Ida Jane Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.12.2]
b. 28 Jun 1894 d. 20 Feb 1968
11
Robert John Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.13]
b. 13 Nov 1869 d. 6 Nov 1954
Susie Winn
b. 10 Feb 1874 d. 8 Sep 1963
12
Ora Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.13.1]
b. 6 May 1897 d. 28 Apr 1956
12
Winnie Leath Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.13.2]
b. 21 Sep 1899 d. 23 Jun 1997 [
=>
]
12
Essie June Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.13.3]
b. 27 Jun 1902 d. 3 Jan 1984 [
=>
]
12
Byron John Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.13.4]
b. 15 Mar 1905 d. 19 Aug 1994 [
=>
]
12
Mildred Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.13.5]
b. 16 Nov 1907 d. 7 May 1987
12
Miriam Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.13.6]
b. 16 Nov 1907 d. 29 Jan 1981 [
=>
]
11
Amey Jane Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.14]
b. 15 Dec 1871 d. 6 Sep 1962
John Henry Evans
b. 29 Apr 1872 d. 24 Mar 1947
12
Emerson Whipple Evans
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.14.1]
b. 7 Apr 1901 d. 26 Mar 1973 [
=>
]
12
Alexander Whipple Evans
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.14.2]
b. 4 Aug 1902 d. 20 Apr 1954 [
=>
]
12
John Henry Evans, Jr
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.14.3]
b. 27 Jan 1903 d. 23 Jun 1988 [
=>
]
12
Gwendolyn Whipple Evans
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.14.4]
b. 2 Feb 1904 d. 21 Sep 1986 [
=>
]
12
Amy Evans
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.14.5]
b. 14 Feb 1909 d. 26 Dec 2001
12
Daughter Evans
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.14.6]
b. 20 Sep 1914 d. 20 Sep 1914
11
Ida Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.15]
b. 15 Dec 1873 d. 21 May 1956
Ezra Oakley Taylor
b. 20 May 1863 d. 19 Jul 1952
12
Mary Whipple Taylor
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.15.1]
b. 11 Feb 1897 d. 16 Apr 1953
12
Julia Whipple Taylor
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.15.2]
b. 6 Aug 1900 d. 27 Apr 1989 [
=>
]
12
Ezra Whipple Taylor
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.15.3]
b. 25 May 1904 d. 21 Jul 2001 [
=>
]
12
Ida Gay Taylor
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.15.4]
b. 19 Oct 1908 d. 23 Dec 2001
12
Irvin Whipple Taylor
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.15.5]
b. 16 Jul 1911 d. 4 Jul 1991 [
=>
]
12
Patricia Taylor
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.15.6]
b. 17 Mar 1919 d. 27 Sep 1997
11
Anor Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.16]
b. 25 Mar 1879 d. 23 Oct 1967
Aurilla May Watkins
b. 4 May 1884 d. 18 Apr 1976
12
Aurilla Gay Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.16.1]
b. 20 Aug 1918 d. 5 Mar 2011 [
=>
]
12
Roswell Watkins Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.16.2]
b. 4 Dec 1922 d. 1 Feb 2008
12
Helen Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.16.3]
b. 5 Feb 1926 d. 6 May 2009
Rachel Keeling
b. 10 Mar 1818 d. 16 Jun 1910
11
Daniel Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.17]
b. 12 Apr 1854 d. 12 Feb 1926
Ellen Hirst
b. 3 Feb 1862 d. 21 Dec 1935
12
Daniel LeRoy Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.17.1]
b. 28 Jul 1879 d. 7 Aug 1935 [
=>
]
12
George Wheeler Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.17.2]
b. 4 Aug 1881 d. 30 Sep 1965 [
=>
]
12
John Ernest Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.17.3]
b. 19 Feb 1883 d. 25 Jan 1946
12
Ella Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.17.4]
b. 27 Jan 1884 d. 29 Sep 1935 [
=>
]
12
Leonard Hirst Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.17.5]
b. 7 Jan 1887 d. 11 Nov 1970 [
=>
]
12
Orley Keeling Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.17.6]
b. 6 Apr 1895 d. 24 Sep 1962 [
=>
]
12
Eugene Brook "Dean" Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.17.7]
b. 29 Dec 1899 d. 31 May 1968 [
=>
]
11
Cynthia Delight Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.18]
b. 7 Jun 1857 d. 4 Sep 1858
11
Nelson Wheeler Whipple, Jr
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.19]
b. 15 Apr 1859 d. 30 Jun 1938
Mary Roberts
b. 15 Jul 1857 d. 23 Sep 1935
12
John Wheeler Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.19.1]
b. 19 Oct 1881 d. 3 Aug 1954 [
=>
]
12
Mable Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.19.2]
b. 4 Jul 1883 d. 8 Oct 1951 [
=>
]
12
Rachel Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.19.3]
b. 20 Dec 1885 d. 1 Jul 1886
12
Nelson Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.19.4]
b. 13 Mar 1887 d. 13 Mar 1887
12
Adelaide Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.19.5]
b. 5 May 1888 d. 21 Feb 1898
12
Lawrence Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.19.6]
b. 24 Sep 1891 d. 2 Apr 1934
12
Lillie May Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.19.7]
b. 6 May 1894 d. 20 Dec 1983 [
=>
]
12
Leslie Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.2.7.19.8]
b. 1 Oct 1898 d. Oct 1957 [
=>
]
9
Richard Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.3]
b. Abt 1781 d. 25 May 1862
9
Roswell Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.4]
b. 1783 d. 25 May 1862
Melinda Gates
b. 26 May 1802 d. Abt 1827
10
Abram Gates Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.4.1]
b. 19 Oct 1826 d. 1913
Roxanna Weeks
b. Apr 1835 d. 18 Oct 1911
11
Emma E Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.4.1.1]
b. 22 Jan 1854
Hannah Weeks
b. 14 Oct 1806 d. 7 Apr 1889
10
William Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.4.2]
b. Mar 1834 d. Aft Jun 1900
10
Sarah Ann Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.4.3]
b. Abt 16 Feb 1834 d. 18 Jan 1919
10
Clarissa Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.4.4]
b. Feb 1838 d. 30 Jul 1921
10
Ella Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.4.5]
b. Abt 1839
10
Jane Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.4.6]
b. 1843
10
Emoline Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.4.7]
b. Abt 1848 d. 31 Mar 1923
10
Caroline Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.4.8]
b. Abt 1848
10
Frank E Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.4.9]
b. May 1857 d. Aft 1904
9
Polly Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.5]
b. Abt 1785
9
Lucy Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.6]
b. Abt 1787
+
Bingham
b. 1783
9
Cynthia Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.10.7]
b. 1789 d. 15 Feb 1856
Ebenezer Root
b. 17 Dec 1760 d. 12 Feb 1842
10
Jerusha Root
[1.1.4.1.3.3.4.10.7.1]
b. 22 Feb 1804 d. 8 Jul 1889
Seth M Johnson
b. 4 Oct 1802 d. 16 Jun 1865
11
Hiram Titus Johnson
[1.1.4.1.3.3.4.10.7.1.1]
b. May 1829 d. 25 Dec 1852
11
Frances Lucia Johnson
[1.1.4.1.3.3.4.10.7.1.2]
b. 1831
11
Daniel Johnson
[1.1.4.1.3.3.4.10.7.1.3]
b. 21 Apr 1833 d. 1915
Mary Augusta Hale
b. 30 Jul 1833 d. 13 Oct 1889
12
Ellen M Johnson
[1.1.4.1.3.3.4.10.7.1.3.1]
b. 1857
12
Alice J Johnson
[1.1.4.1.3.3.4.10.7.1.3.2]
b. 1860
12
Charles H Johnson
[1.1.4.1.3.3.4.10.7.1.3.3]
b. 1861
12
Mary L Johnson
[1.1.4.1.3.3.4.10.7.1.3.4]
b. 1867
12
F Mary Johnson
[1.1.4.1.3.3.4.10.7.1.3.5]
b. 28 Oct 1873 [
=>
]
11
Charles Johnson
[1.1.4.1.3.3.4.10.7.1.4]
b. 1835
11
Ellen A Johnson
[1.1.4.1.3.3.4.10.7.1.5]
b. 1837 d. 27 Jul 1853
11
Robert L Johnson
[1.1.4.1.3.3.4.10.7.1.6]
b. 1839 d. 18 Nov 1864
11
Mary A Johnson
[1.1.4.1.3.3.4.10.7.1.7]
b. 1842
11
Esther L Johnson
[1.1.4.1.3.3.4.10.7.1.8]
b. 1844
11
Sarah A Johnson
[1.1.4.1.3.3.4.10.7.1.9]
b. 19 Nov 1847
10
Charlotte Root
[1.1.4.1.3.3.4.10.7.2]
b. 5 Jul 1805 d. 26 Oct 1900
Ira Dibble
b. 13 Apr 1795 d. 31 May 1837
11
Ira Wilson Dibble
[1.1.4.1.3.3.4.10.7.2.1]
b. 10 Dec 1827 d. 18 Dec 1902
Sarah Root Bordwell
b. 28 Feb 1834 d. 21 Aug 1895
12
Francelia Dibble
[1.1.4.1.3.3.4.10.7.2.1.1]
b. 16 Apr 1852
12
Cornelia Dibble
[1.1.4.1.3.3.4.10.7.2.1.2]
b. 14 Jul 1856
12
Georgen Lewis Dibble
[1.1.4.1.3.3.4.10.7.2.1.3]
b. 16 Jan 1860
11
William Warner Dibble
[1.1.4.1.3.3.4.10.7.2.2]
b. 10 Dec 1833 d. 24 Oct 1895
Diana Adelia Calkins
b. 1835
12
William Jackson Dibble
[1.1.4.1.3.3.4.10.7.2.2.1]
b. 26 Aug 1868 d. 8 Dec 1947 [
=>
]
10
Polly Root
[1.1.4.1.3.3.4.10.7.3]
b. 16 Apr 1807 d. 9 Dec 1853
10
Daniel W Root
[1.1.4.1.3.3.4.10.7.4]
b. 29 May 1809 d. 23 Oct 1846
10
Harriet Root
[1.1.4.1.3.3.4.10.7.5]
b. 27 Aug 1811 d. 26 Oct 1901
10
Alanson Root
[1.1.4.1.3.3.4.10.7.6]
b. 19 Nov 1814 d. 1817
10
Cyras Root
[1.1.4.1.3.3.4.10.7.7]
b. 10 Feb 1817
10
Silas Root
[1.1.4.1.3.3.4.10.7.8]
b. 10 Feb 1817 d. 1 Apr 1904
8
Thomas Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.11]
b. 16 Mar 1751 d. 1833
Lydia Gates
b. Abt 1761 d. 17 Mar 1795
9
Lydia Gates Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.11.1]
b. 24 Jul 1779 d. 1 Sep 1864
Jonathan Carver Ames
b. 18 Mar 1774 d. 26 Apr 1853
10
Alvin Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.1]
b. 8 Mar 1800 d. 11 Jun 1870
Patricia Ames
b. Abt 1802
11
Hamilton E Aymes
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.1.1]
b. 1828
11
William Ransom Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.1.2]
b. 1831
11
Susan V Aymes
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.1.3]
b. 1841
11
Alvin M Aymes
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.1.4]
b. 1845
11
Jerusa Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.1.5]
10
Chester Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.2]
b. 9 May 1801 d. 28 Aug 1891
Susanna D Pitts
b. 2 Sep 1805 d. 26 Apr 1887
11
Caroline Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.2.1]
b. 3 Oct 1826 d. 17 Apr 1827
11
Lucille A Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.2.2]
b. 22 May 1828 d. 13 May 1909
Thomas William Frazier
b. 29 Jan 1827 d. 2 Apr 1889
12
Susanna Frazier
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.2.2.1]
b. 2 Nov 1852
12
Clarissa F Frazier
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.2.2.2]
b. 30 Apr 1853
12
Jennie Frazier
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.2.2.3]
b. 6 Nov 1854 d. 26 Mar 1929 [
=>
]
12
Theodore Frazier
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.2.2.4]
b. 23 Aug 1859 d. 2 Apr 1889
12
Thomas W Frazier
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.2.2.5]
b. 3 Jun 1866 [
=>
]
11
Apollos Pitts Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.2.3]
b. 22 May 1830 d. 10 Sep 1899
+
Dimis W Webb
b. 1836 d. 1902
11
Thomas Whipple Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.2.4]
b. 10 May 1832 d. 10 Nov 1917
Melissa Melinda Cole
b. Abt 1835
12
Herbert Curtis Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.2.4.1]
b. 18 Aug 1859 d. 9 Sep 1949 [
=>
]
12
Thomas W Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.2.4.2]
b. Abt 1863
12
Alford Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.2.4.3]
b. Abt 1866
12
Apollos Pitt Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.2.4.4]
b. 25 Nov 1868 d. 30 Oct 1948 [
=>
]
12
Lewis H Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.2.4.5]
b. Abt 1871
12
Chester Chandler Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.2.4.6]
b. Oct 1875 d. 1963
12
Cora Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.2.4.7]
b. 1877
11
Alvin Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.2.5]
b. Abt 1834
+
Eliza M Church
11
Olivia L Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.2.6]
b. Aug 1835 d. 28 Dec 1909
Alexander Trotter
b. 3 Jul 1832 d. 4 Jun 1894
12
George Alexander Trotter
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.2.6.1]
b. Jun 1857 d. 5 Apr 1860
12
William Alexander Trotter
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.2.6.2]
b. 4 Aug 1858 d. 3 Jul 1924 [
=>
]
12
Helen S Trotter
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.2.6.3]
b. 15 Aug 1941 d. 1932 [
=>
]
12
Fred Eugene Trotter
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.2.6.4]
b. Jan 1865 d. 5 May 1924
12
Albert Marion Trotter
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.2.6.5]
b. Feb 1866 d. 23 May 1938 [
=>
]
12
Richard Gardner Trotter
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.2.6.6]
b. 1870 [
=>
]
12
Mary Louise Trotter
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.2.6.7]
b. 17 Nov 1872 d. 21 Apr 1926
12
John P Trotter
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.2.6.8]
b. Apr 1875 d. 1940 [
=>
]
12
Lucy Dimis Trotter
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.2.6.9]
b. Jan 1879 d. 14 Sep 1931 [
=>
]
12
Frank Trotter
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.2.6.10]
b. Sep 1871 d. 5 Apr 1860
11
Chester L Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.2.7]
b. 27 Aug 1839 d. 31 Jul 1897
Maria Shepard
b. 5 May 1842 d. 4 Aug 1867
12
James Pitts Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.2.7.1]
b. 8 Jan 1865 d. 1914
12
Son Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.2.7.2]
b. Abt 1867
11
Mary F Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.2.8]
b. 15 Jun 1843 d. 10 Oct 1913
11
Marion Frances Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.2.9]
b. 15 Jun 1843 d. 28 Jun 1924
Ellen F Crawford
b. 10 Sep 1846 d. 28 Jul 1934
12
Marion W Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.2.9.1]
b. Dec 1891 d. 20 Dec 1937 [
=>
]
12
Florence E Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.2.9.2]
b. Abt 1900
11
Benjamin Willard Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.2.10]
b. 16 Feb 1845 d. 1 Oct 1873
+
Hannah Mary Sluman
b. 1850
10
Joseph Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.3]
b. 28 Sep 1802 d. 11 Apr 1851
Rebecca Ames
b. 1815
11
Sally Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.3.1]
b. 1836
11
Simeon Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.3.2]
b. 1841
11
Frederick Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.3.3]
b. 1846
11
Minerva Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.3.4]
b. 1848
10
Mary Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.4]
b. 3 Feb 1804 d. 23 Nov 1884
10
Johnathan Carver Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.5]
b. 18 Apr 1807 d. 26 Mar 1868
Lucy P Ames
b. Abt 1810 d. Mar 1886
11
Jonathan C Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.5.1]
b. 1830
11
Roderick Dhu Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.5.2]
b. 2 Sep 1832 d. 31 Mar 1914
Catharine Barbara Sessler
b. 24 Feb 1842 d. 7 Nov 1925
12
Francelia B Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.5.2.1]
b. 10 Nov 1861 d. 9 Apr 1911 [
=>
]
12
Emma L Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.5.2.2]
b. 9 Oct 1863 d. 27 Jan 1939
12
Philo J Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.5.2.3]
b. 4 Feb 1867 d. 27 Mar 1942 [
=>
]
12
Clarence Edward Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.5.2.4]
b. 26 Sep 1868 d. 15 Nov 1937
12
Roderick Allen Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.5.2.5]
b. 6 Jun 1870 d. 20 Aug 1910
12
Martin H Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.5.2.6]
b. 1 Jan 1872 d. 21 Feb 1886
12
Henry Conrad Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.5.2.7]
b. 10 Aug 1874 d. 18 Aug 1940 [
=>
]
12
Juliann S Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.5.2.8]
b. 15 Oct 1877 d. 1939 [
=>
]
12
John Sessler Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.5.2.9]
b. 5 Sep 1879 d. 18 Aug 1941
11
Samuel E Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.5.3]
b. 27 Dec 1833
10
Thomas Whipple Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.6]
b. 7 Apr 1808 d. 18 Jan 1885
10
Walter Whipple Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.7]
b. 21 Jun 1810 d. 26 Apr 1887
Amelia Stratten
b. 22 Apr 1821 d. 1 Oct 1905
11
Levi F Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.7.1]
b. Mar 1840 d. 16 Jun 1923
11
Albert Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.7.2]
b. 1847
11
Adelbert Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.7.3]
b. 1848
11
Delbert Calvin Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.7.4]
b. 21 Mar 1848 d. 9 Feb 1937
11
Albro Joseph Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.7.5]
b. 21 Mar 1851 d. 14 Nov 1934
11
Josephine Emma Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.7.6]
b. 1853
11
Emily Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.7.7]
b. 1856
10
Caroline Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.8]
b. 1 Apr 1811 d. 17 Apr 1828
10
Valeria Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.9]
b. 24 Jun 1813 d. 15 Sep 1856
10
Levi Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.10]
b. 11 Jun 1816 d. 31 Jul 1909
10
Phoebe Tabor Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.11]
b. 18 Jun 1818
Elijah Ames
b. 23 Feb 1813 d. 10 Nov 1885
11
Lydia W Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.11.1]
b. 1844
Jerome Bonnaparte Story
b. Dec 1840
12
Franklin S Story
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.11.1.1]
b. 5 Sep 1862 d. 15 Oct 1862
12
William A Story
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.11.1.2]
b. 7 Mar 1866 d. 7 Apr 1866
12
Jerome Story
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.11.1.3]
b. 1867
12
William Almon Story
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.11.1.4]
b. 1874 [
=>
]
11
Edmond H Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.11.2]
b. 19 Oct 1846 d. 7 Mar 1917
Ellen B Grandy
b. 18 Mar 1845
12
Fred Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.11.2.1]
b. Aug 1879
11
Rizpah Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.11.3]
b. 8 Oct 1848 d. 18 May 1917
Oscar F Grandy
b. 28 Feb 1842 d. 18 Jan 1901
12
Watie Desire Grandy
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.11.3.1]
b. 17 Jun 1878 d. 10 Oct 1948 [
=>
]
12
Edmond Grandy
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.11.3.2]
b. 11 Jul 1880 d. 5 Jan 1965
12
Leurtus A Grandy
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.11.3.3]
b. 2 Aug 1882 d. 17 Oct 1954
12
Agusta Grandy
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.11.3.4]
b. 6 Jun 1886 d. 28 Dec 1970 [
=>
]
12
Benjamin Harrison Grandy
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.11.3.5]
b. 31 Aug 1888 d. 19 Sep 1971
12
Gertrude Edwina Grandy
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.11.3.6]
b. 1 Nov 1890 d. 5 Mar 1891
12
Raymond Oscar Grandy
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.11.3.7]
b. 1 Nov 1894 d. 27 Dec 1970
11
Truman Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.11.4]
b. 25 Jun 1851 d. 20 Mar 1939
Ella Anna "Nellie" Doyen
b. Oct 1857 d. 1907
12
Jay H Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.11.4.1]
b. Oct 1885 d. Abt 1932
12
Howard T Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.11.4.2]
b. 31 Jul 1887 d. Aft 1939
11
Waittie M Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.11.5]
b. Sep 1854
11
Patsy L Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.11.6]
b. Feb 1858
11
Luella Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.11.7]
b. 6 Jan 1860 d. 10 Oct 1943
10
Lydia Whipple Ames
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.12]
b. 15 Nov 1820 d. 25 Feb 1903
Benjamin F Knowlton
b. 6 Dec 1822 d. 4 Jun 1906
11
George C Knowlton
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.12.1]
b. Oct 1846 d. 14 Oct 1922
Sarah Jane Willard
b. 26 Apr 1850 d. 18 Oct 1923
12
Chester H Knowlton
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.12.1.1]
b. 17 Mar 1876 d. 31 Dec 1952
12
Lulu B Knowlton
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.12.1.2]
b. Abt 1876 [
=>
]
12
Raymond Willard Knowlton
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.12.1.3]
b. 7 Oct 1878 d. 22 Jun 1950 [
=>
]
12
Beulah D Knowlton
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.12.1.4]
b. Mar 1881 [
=>
]
11
Phebe A Knowlton
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.12.2]
b. Oct 1852 d. Jul 1937
Abram M Sherman
b. 26 Apr 1837 d. Jan 1922
12
Clara Sherman
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.12.2.1]
b. May 1874
11
Eugene F Knowlton
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.12.3]
b. Sep 1854 d. 11 May 1938
Laura A Wilcox
b. 20 Jul 1852 d. 4 Apr 1933
12
Abigail Knowlton
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.12.3.1]
b. Jan 1885 d. 1944 [
=>
]
12
Lydia Belle Knowlton
[1.1.4.1.3.3.4.11.1.12.3.2]
b. 19 Oct 1890 d. 29 Sep 1970
9
Thomas Jefferson Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.11.2]
b. 1787 d. 23 Jan 1835
Phebe Taber
b. Aug 1784 d. 17 Aug 1823
10
Alonzo A Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.11.2.1]
b. 27 Feb 1811 d. 11 Mar 1887
Deborah D Parker
b. 1814 d. 11 Aug 1873
11
Thomas D Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.11.2.1.1]
b. Abt 1836 d. Bef 1913
11
Alonzo A Whipple, Jr
[1.1.4.1.3.3.4.11.2.1.2]
b. Abt 1838 d. 13 Jul 1869
Mary E Caykendall
b. Abt 1844 d. 25 Aug 1869
12
Walter A Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.11.2.1.2.1]
b. 1 Jan 1869 d. 17 Sep 1869
11
Rhoda A Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.11.2.1.3]
b. 30 May 1838 d. 28 Aug 1910
James S Smith
b. 27 May 1831 d. 8 Aug 1910
12
Netta D Smith
[1.1.4.1.3.3.4.11.2.1.3.1]
b. 1865
12
Jennie E Smith
[1.1.4.1.3.3.4.11.2.1.3.2]
b. 1869
12
Caroline Smith
[1.1.4.1.3.3.4.11.2.1.3.3]
b. 1 Mar 1873 d. 4 May 1926
12
Effie W Smith
[1.1.4.1.3.3.4.11.2.1.3.4]
b. 11 Aug 1875 d. 16 Feb 1943
11
George F Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.11.2.1.4]
b. Abt 1840 d. Bef 1913
11
Lewis B Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.11.2.1.5]
b. 13 Jun 1842 d. 13 Jul 1867
11
Deborah Parker Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.11.2.1.6]
b. 20 Mar 1845 d. 19 May 1913
Frank Gardner Beaman
b. 7 Feb 1846 d. 13 Nov 1938
12
Charles L'Heureux Beaman
[1.1.4.1.3.3.4.11.2.1.6.1]
b. 15 Jun 1873 d. 1 Sep 1941 [
=>
]
12
Edwin Frank Beaman
[1.1.4.1.3.3.4.11.2.1.6.2]
b. 31 Aug 1875 d. Aft 1941
12
Thomas Whipple Beaman
[1.1.4.1.3.3.4.11.2.1.6.3]
b. 29 Aug 1887 d. Aft 1941
11
Mary Frances Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.11.2.1.7]
b. 1850
+
John A Page
b. 1867
11
Walter G Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.11.2.1.8]
b. Abt 1854 d. Aft 1913
10
Thomas Jefferson Whipple, Jr
[1.1.4.1.3.3.4.11.2.2]
b. 30 Jan 1816 d. 21 Dec 1889
Belinda Butler Hadley
b. 1 May 1820 d. 14 Nov 1854
11
Belinda Caroline Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.11.2.2.1]
b. 18 Aug 1846 d. Aft 1889
George R Somes
b. 13 Dec 1845 d. Aft 1880
12
Gertrude W Somes
[1.1.4.1.3.3.4.11.2.2.1.1]
b. Abt 1869
10
Caroline B Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.11.2.3]
b. 1 Apr 1820 d. 5 Oct 1910
George Flanders
b. 17 May 1822 d. 2 Mar 1895
11
Caroline M Flanders
[1.1.4.1.3.3.4.11.2.3.1]
b. Jan 1851 d. 17 Sep 1851
11
Emily Flanders
[1.1.4.1.3.3.4.11.2.3.2]
b. 19 Jan 1854
9
Mattie Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.11.3]
b. 8 May 1789 d. 4 Sep 1877
Paul Tabor
b. 12 Aug 1788 d. 3 Sep 1878
10
Mialma Tabor
[1.1.4.1.3.3.4.11.3.1]
b. 8 Jan 1814 d. 26 Aug 1894
John Densmore
b. 18 Nov 1805 d. 19 Sep 1851
11
Sarah E Densmore
[1.1.4.1.3.3.4.11.3.1.1]
b. 1838
11
John Densmore
[1.1.4.1.3.3.4.11.3.1.2]
b. 1840
11
Marietta Tabor Densmore
[1.1.4.1.3.3.4.11.3.1.3]
b. 11 Jul 1843 d. 1 Oct 1915
Lewis Cass Judson
b. 3 Sep 1844 d. 16 Dec 1915
12
Thomas Marshall Judson
[1.1.4.1.3.3.4.11.3.1.3.1]
b. 18 Mar 1867 d. 19 Dec 1941 [
=>
]
12
Florence Louise Judson
[1.1.4.1.3.3.4.11.3.1.3.2]
b. 1 Nov 1869 [
=>
]
12
Jessie Alma Judson
[1.1.4.1.3.3.4.11.3.1.3.3]
b. 9 Oct 1872
12
John Lewis Judson
[1.1.4.1.3.3.4.11.3.1.3.4]
b. 4 Jan 1875 d. 1941 [
=>
]
12
Bertie L Judson
[1.1.4.1.3.3.4.11.3.1.3.5]
b. 11 Jul 1878 d. 9 Aug 1878
12
Son Judson
[1.1.4.1.3.3.4.11.3.1.3.6]
b. 27 Apr 1881 d. 2 May 1881
11
Isabella Densmore
[1.1.4.1.3.3.4.11.3.1.4]
b. 1845
11
Amanda Densmore
[1.1.4.1.3.3.4.11.3.1.5]
b. 14 Apr 1848
Lucien Bowen Smith
b. 23 Feb 1843 d. Aft 1893
12
Florence B Smith
[1.1.4.1.3.3.4.11.3.1.5.1]
b. Apr 1868
10
Ann Tabor
[1.1.4.1.3.3.4.11.3.2]
b. 5 Jul 1828 d. 29 Nov 1904
Lucien Bonaparte Bowen
b. 8 Aug 1817 d. 27 Oct 1863
11
Mary Bowen
[1.1.4.1.3.3.4.11.3.2.1]
b. 13 Dec 1848 d. 13 Jan 1849
11
Florence Bowen
[1.1.4.1.3.3.4.11.3.2.2]
b. 31 Jan 1850 d. 31 Dec 1878
+
Frank H Tabor
b. 10 Jul 1850 d. 22 Jan 1879
11
Paul Tabor Bowen
[1.1.4.1.3.3.4.11.3.2.3]
b. 9 Mar 1852
11
George Wood Bowen
[1.1.4.1.3.3.4.11.3.2.4]
b. 4 Mar 1854
11
Laurah Jessie Bowen
[1.1.4.1.3.3.4.11.3.2.5]
b. 30 Jan 1856 d. 15 Jan 1859
11
Annie Patience Bowen
[1.1.4.1.3.3.4.11.3.2.6]
b. 21 Feb 1858
Floyd Thomas Frost
b. 29 Nov 1846
12
Paul Delavan Frost
[1.1.4.1.3.3.4.11.3.2.6.1]
b. 29 Feb 1880
12
Annie May Frost
[1.1.4.1.3.3.4.11.3.2.6.2]
b. 24 Aug 1884
11
Luciene Bowen
[1.1.4.1.3.3.4.11.3.2.7]
b. Dec 1861 d. Jan 1862
9
Son Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.11.4]
b. Bef 1790 d. Aft 1790
9
Walter Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.11.5]
b. 28 Feb 1792 d. 24 Dec 1882
Susan A Donaldson
b. Abt 1795
10
Lothario Danielson Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.11.5.1]
b. 14 Sep 1831 d. 18 Nov 1847
Ruth Baker
b. Abt 1806 d. Aft 1880
10
Susan Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.11.5.2]
b. 1846
10
James Henry Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.11.5.3]
b. Dec 1857
Emma Amelia Packard
b. 9 May 1851 d. 19 May 1939
11
Maggie Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.11.5.3.1]
b. 25 Aug 1871
11
George C Whipple
[1.1.4.1.3.3.4.11.5.3.2]
b. 20 Jul 1875 d. 11 Feb 1922
+
Harriet L Groetzinger
b. Abt 1876
7
Patience Whipple
[1.1.4.1.3.3.5]
b. Abt 1709
+
John Olney
b. Abt 1707
7
Noah Whipple
[1.1.4.1.3.3.6]
b. Abt 1711
7
Nathan Whipple
[1.1.4.1.3.3.7]
b. Abt 1713
6
Abigail Whipple
[1.1.4.1.3.4]
b. 1683 d. 18 Sep 1735
Robert Currie
b. Abt 1680 d. Abt 1745
7
Samuel Currie
[1.1.4.1.3.4.1]
b. 4 Oct 1719 d. 31 Dec 1770
7
John Currie
[1.1.4.1.3.4.2]
b. 3 Jun 1721
7
James Currie
[1.1.4.1.3.4.3]
b. 3 Dec 1722
6
Hope Whipple
[1.1.4.1.3.5]
b. Abt 1685 d. 14 Feb 1716
+
Robert Currie
b. Abt 1680 d. Abt 1745
5
Thomas Harris
[1.1.4.1.4]
b. 1641 d. 27 Feb 1711
Elnathan Tew
b. 15 Oct 1644 d. 11 Jan 1718
6
Thomas Harris
[1.1.4.1.4.1]
b. 19 Oct 1665 d. 1 Sep 1741
6
Richard Harris
[1.1.4.1.4.2]
b. 14 Oct 1668 d. 18 Aug 1750
Elizabeth Lydia King
b. 1670 d. 28 Mar 1736
7
Amity Harris
[1.1.4.1.4.2.1]
b. 10 Oct 1697 d. 5 May 1749
7
Uriah Harris
[1.1.4.1.4.2.2]
b. 1700 d. 14 Apr 1729
7
Amaziah Harris
[1.1.4.1.4.2.3]
b. 13 Apr 1705 d. Aft 6 Mar 1738
7
Richard Harris
[1.1.4.1.4.2.4]
b. 4 Oct 1708 d. May 1784
7
Jonathan Harris
[1.1.4.1.4.2.5]
b. 12 Jul 1710 d. 24 Sep 1785
Mary Whipple Brown
b. 8 Apr 1709 d. 1 Dec 1740
8
Abner Harris
[1.1.4.1.4.2.5.1]
b. 10 Jun 1730 d. 16 Mar 1768
8
Jabez Harris
[1.1.4.1.4.2.5.2]
b. 1732 d. 1776
8
Mary Harris
[1.1.4.1.4.2.5.3]
b. 1734 d. 11 Jan 1785
8
Dinah Harris
[1.1.4.1.4.2.5.4]
b. 21 Oct 1737 d. 1821
7
David Harris
[1.1.4.1.4.2.6]
b. 7 Jan 1714 d. 31 Mar 1797
7
Preserved Harris
[1.1.4.1.4.2.7]
b. 15 Jun 1715 d. 4 May 1797
Martha Mowry
b. 1 Apr 1726 d. Apr 1774
8
Urania Harris
[1.1.4.1.4.2.7.1]
b. 2 Apr 1745 d. Bef 1794
8
Israel Harris
[1.1.4.1.4.2.7.2]
b. 14 Mar 1747 d. 5 Jul 1811
8
Rufus Harris
[1.1.4.1.4.2.7.3]
b. 23 Nov 1749 d. 30 May 1798
8
Lydia Harris
[1.1.4.1.4.2.7.4]
b. 8 May 1752 d. 8 Dec 1795
Nathaniel Spaulding
b. 15 Jul 1751 d. 10 Jun 1838
9
Amey Spaulding
[1.1.4.1.4.2.7.4.1]
b. 16 Feb 1775
8
Elnathan Harris
[1.1.4.1.4.2.7.5]
b. 21 Aug 1755 d. 22 Dec 1823
Oliver Arnold
b. 12 Apr 1752 d. 18 Jan 1790
9
Isaac Arnold
[1.1.4.1.4.2.7.5.1]
b. 11 Aug 1779 d. 12 Nov 1861
9
Oliver Arnold
[1.1.4.1.4.2.7.5.2]
b. 11 Apr 1781 d. 18 Apr 1785
9
Martin Arnold
[1.1.4.1.4.2.7.5.3]
b. 11 Nov 1783 d. 28 Oct 1847
+
Mary Spaulding
b. 16 Mar 1801 d. 29 Jul 1863
9
Sabera Arnold
[1.1.4.1.4.2.7.5.4]
b. 25 Jan 1786 d. 25 Nov 1873
9
Preserved Arnold
[1.1.4.1.4.2.7.5.5]
b. 10 Jun 1788 d. 10 Jul 1828
8
Nathan Harris
[1.1.4.1.4.2.7.6]
b. 23 Mar 1758 d. 11 Nov 1835
8
Jesse Harris
[1.1.4.1.4.2.7.7]
b. 6 Aug 1760 d. 8 Jun 1803
8
Martin Harris
[1.1.4.1.4.2.7.8]
b. 24 Feb 1764 d. 6 May 1797
8
Nathaniel Harris
[1.1.4.1.4.2.7.9]
b. 9 Jan 1774
6
Nicholas Harris
[1.1.4.1.4.3]
b. 15 Apr 1671 d. 27 Mar 1746
6
William Harris
[1.1.4.1.4.4]
b. 11 May 1673 d. 14 Jan 1726
6
Henry Harris
[1.1.4.1.4.5]
b. 10 Nov 1675 d. 29 Mar 1727
Lydia Olney
b. 26 Jan 1688 d. 1727
7
Thomas Harris
[1.1.4.1.4.5.1]
b. 1697 d. 23 Apr 1736
7
Henry Harris
[1.1.4.1.4.5.2]
b. 1699 d. 4 Mar 1738
7
Epenetus Harris
[1.1.4.1.4.5.3]
b. 21 Sep 1713
7
Lydia Harris
[1.1.4.1.4.5.4]
b. 1714 d. 1737
7
Elizabeth Harris
[1.1.4.1.4.5.5]
b. 11 Feb 1715
7
Elnathan Harris
[1.1.4.1.4.5.6]
b. 2 Dec 1717
7
Mary Harris
[1.1.4.1.4.5.7]
b. 9 Mar 1722
6
Amity Harris
[1.1.4.1.4.6]
b. 10 Dec 1677 d. 5 Jun 1749
6
Mary Harris
[1.1.4.1.4.7]
b. 1682 bur. 13 Sep 1765
5
Martha Harris
[1.1.4.1.5]
b. Abt 1643 d. 10 Aug 1717
Thomas Field
b. 28 May 1648 d. 10 Aug 1717
6
Amos Field
[1.1.4.1.5.1]
b. Abt 1677 d. Abt 1680
6
Elizabeth Field
[1.1.4.1.5.2]
b. 27 Aug 1670 d. 24 Jan 1709
6
William Field
[1.1.4.1.5.3]
b. 8 Jun 1682 d. 5 Nov 1729
6
Mary Field
[1.1.4.1.5.4]
b. 1 Jan 1671 d. Jun 1727
John Dexter
b. 1673 d. 22 Apr 1734
7
Naomi Dexter
[1.1.4.1.5.4.1]
b. 1698 d. 12 Dec 1777
Thomas Whipple
b. 26 Feb 1693 d. 13 Oct 1770
8
Abigail Whipple
[1.1.4.1.5.4.1.1]
b. 18 Jul 1721
8
Margery Whipple
[1.1.4.1.5.4.1.2]
b. 9 Sep 1722
8
Thomas Whipple
[1.1.4.1.5.4.1.3]
b. 8 Jul 1725 d. 4 Dec 1777
Anna Harris
b. 22 Apr 1732 d. 15 Jul 1789
9
Nicholas Whipple
[1.1.4.1.5.4.1.3.1]
b. 1751
9
Christopher Whipple
[1.1.4.1.5.4.1.3.2]
b. 1754 d. 1787
Sarah Cushing
b. 21 Apr 1782
10
Abigail Eliza Whipple
[1.1.4.1.5.4.1.3.2.1]
b. 21 Sep 1786 d. 6 Feb 1873
Captain Wilber Kelly
b. 1782 d. 29 Oct 1846
11
Christopher Whipple Kelly
[1.1.4.1.5.4.1.3.2.1.1]
b. 1811 d. 30 Mar 1858
Caroline Dexter
b. Abt 1812 d. 6 Jun 1866
12
Mary Kelly
[1.1.4.1.5.4.1.3.2.1.1.1]
b. 27 Feb 1832 d. 10 Sep 1906 [
=>
]
12
George D Kelly
[1.1.4.1.5.4.1.3.2.1.1.2]
b. 1835 d. 19 Feb 1891 [
=>
]
12
Anna Kelly
[1.1.4.1.5.4.1.3.2.1.1.3]
b. 1835 d. 1 Jan 1905 [
=>
]
12
Caroline Dexter Kelly
[1.1.4.1.5.4.1.3.2.1.1.4]
b. 1848 d. 16 Mar 1935
11
George Kelly
[1.1.4.1.5.4.1.3.2.1.2]
b. 1 Apr 1813 d. 2 Sep 1880
11
Abby Whipple Kelly
[1.1.4.1.5.4.1.3.2.1.3]
b. 2 Jun 1820 d. 10 Jan 1884
11
Robert L Kelly
[1.1.4.1.5.4.1.3.2.1.4]
b. 1825 d. 14 Mar 1863
9
George Whipple
[1.1.4.1.5.4.1.3.3]
b. 1760 d. 1 Aug 1848
9
Thomas Whipple
[1.1.4.1.5.4.1.3.4]
b. 17 Sep 1766 d. 7 Sep 1843
9
Amy Whipple
[1.1.4.1.5.4.1.3.5]
b. 1770
8
Siboleth or Sybil Whipple
[1.1.4.1.5.4.1.4]
b. 23 Oct 1726 d. 1 Oct 1793
8
Naomi Whipple
[1.1.4.1.5.4.1.5]
b. 28 Oct 1728
8
Anne Whipple
[1.1.4.1.5.4.1.6]
b. 14 Nov 1730
8
Levi Whipple
[1.1.4.1.5.4.1.7]
b. 4 Sep 1734
8
Voshty Whipple
[1.1.4.1.5.4.1.8]
b. 18 Nov 1736
8
Zilpah Whipple
[1.1.4.1.5.4.1.9]
b. 30 Oct 1737 d. 3 Sep 1767
7
Mary Dexter
[1.1.4.1.5.4.2]
b. 1699
Noah Whipple, Jr
b. 18 Dec 1697 d. 29 Feb 1784
8
Freelove Whipple
[1.1.4.1.5.4.2.1]
b. 1736
Benjamin Pitts
b. 6 Nov 1754
9
James Pitts
[1.1.4.1.5.4.2.1.1]
b. 5 Dec 1780
9
Marcy Whipple Pitts
[1.1.4.1.5.4.2.1.2]
b. 14 Dec 1783
8
Susannah Whipple
[1.1.4.1.5.4.2.2]
b. Abt 1723 d. 1804
Elisha Angell
b. 13 Oct 1719 d. 14 Nov 1755
9
Enoch Angell
[1.1.4.1.5.4.2.2.1]
b. 15 Oct 1742 d. 17 Feb 1832
Amey Randall
b. Abt May 1751 d. 17 Dec 1767
10
Randall Angell
[1.1.4.1.5.4.2.2.1.1]
b. 30 Nov 1767 d. 5 Sep 1855
Marcy Angell
b. 5 Nov 1767 d. 5 Apr 1837
11
Dexter Angell
[1.1.4.1.5.4.2.2.1.1.1]
b. 28 May 1790 d. 17 Nov 1841
11
Amey Angell
[1.1.4.1.5.4.2.2.1.1.2]
b. 4 Apr 1791
11
Whipple Angell
[1.1.4.1.5.4.2.2.1.1.3]
b. 6 Oct 1794 d. 2 Jul 1862
11
Selena Angell
[1.1.4.1.5.4.2.2.1.1.4]
b. 5 Jul 1796
11
Brown Angell
[1.1.4.1.5.4.2.2.1.1.5]
b. 13 Oct 1801 d. 3 Aug 1878
11
Julianna Angell
[1.1.4.1.5.4.2.2.1.1.6]
b. 16 Apr 1804 d. 22 May 1836
11
Olney Angell
[1.1.4.1.5.4.2.2.1.1.7]
b. 16 Dec 1808
11
Esten Angell
[1.1.4.1.5.4.2.2.1.1.8]
b. 16 Dec 1808 d. 19 Mar 1889
Freelove Randall
b. 16 Jun 1749 d. 7 Feb 1778
10
Elisha Angell
[1.1.4.1.5.4.2.2.1.2]
b. 21 May 1770 d. 25 Feb 1846
Abigail Cushing
b. 1773 d. 11 Feb 1843
11
Cushing Angell
[1.1.4.1.5.4.2.2.1.2.1]
b. 7 Dec 1794 d. 4 Jun 1886
Mahala Pearce
b. 10 Apr 1795 d. 24 Nov 1877
12
Mercy A. Angell
[1.1.4.1.5.4.2.2.1.2.1.1]
b. 9 Aug 1834 d. 23 Mar 1877
12
Amos Pearce Angell
[1.1.4.1.5.4.2.2.1.2.1.2]
b. 19 Jun 1836 d. 3 Jun 1840
11
Alfred Angell
[1.1.4.1.5.4.2.2.1.2.2]
b. 24 Aug 1796 d. 15 May 1867
+
Mary Cushing
+
Julia A Hawkins
b. 1813
11
Stephen Angell
[1.1.4.1.5.4.2.2.1.2.3]
b. 31 Dec 1798 d. 18 Mar 1859
11
Shadrach Angell
[1.1.4.1.5.4.2.2.1.2.4]
b. 22 May 1801 d. 10 Aug 1838
11
Freelove Angell
[1.1.4.1.5.4.2.2.1.2.5]
b. 9 Jun 1805 d. 1889
11
Mary Cushing Angell
[1.1.4.1.5.4.2.2.1.2.6]
b. 17 Jun 1808 d. 17 Jun 1808
10
Stephen Angell
[1.1.4.1.5.4.2.2.1.3]
b. Abt 20 Mar 1776 d. 1 Feb 1818
10
Nathaniel Angel
[1.1.4.1.5.4.2.2.1.4]
b. 12 Mar 1780 d. 3 Aug 1832
Asha Smith
b. 23 Sep 1800 d. 20 Oct 1870
11
Amey Randall Angell
[1.1.4.1.5.4.2.2.1.4.1]
b. 8 Aug 1827 d. 28 Mar 1920
Obadiah Brown
b. 30 Nov 1823 d. 2 Feb 1907
12
Anna M Brown
[1.1.4.1.5.4.2.2.1.4.1.1]
b. 1851
12
Mary L Brown
[1.1.4.1.5.4.2.2.1.4.1.2]
b. 1858 d. 31 May 1876
12
Mabel Brown
[1.1.4.1.5.4.2.2.1.4.1.3]
b. 1862 d. 8 Jun 1928
12
Adelaide V Brown
[1.1.4.1.5.4.2.2.1.4.1.4]
b. 1867 d. 20 Feb 1929
11
Ann Maria Angell
[1.1.4.1.5.4.2.2.1.4.2]
b. Abt 28 May 1829 d. 19 Feb 1833
9
Mary Angel
[1.1.4.1.5.4.2.2.2]
b. 4 Oct 1744
Jonathan Comstock
b. 7 Sep 1737 d. 4 Dec 1784
10
Felix Comstock
[1.1.4.1.5.4.2.2.2.1]
b. 1770 d. 22 Jul 1822
10
Thomas Comstock
[1.1.4.1.5.4.2.2.2.2]
b. 7 May 1775 d. 7 Sep 1834
10
Ichabod Comstock
[1.1.4.1.5.4.2.2.2.3]
b. 1776 bur. Jan 1775
10
Lucy Comstock
[1.1.4.1.5.4.2.2.2.4]
b. 1778
9
Abner Angell
[1.1.4.1.5.4.2.2.3]
b. 1746
+
Almyra Whitman
b. 1782
9
Martha Angell
[1.1.4.1.5.4.2.2.4]
b. Abt 19 May 1750 d. 8 Jun 1790
David Soule
b. 1741
10
Thomas Soule
[1.1.4.1.5.4.2.2.4.1]
b. 1784
10
Constant Soule
[1.1.4.1.5.4.2.2.4.2]
b. 14 May 1785
10
Samuel Soule
[1.1.4.1.5.4.2.2.4.3]
b. 1796
9
Isaac Angell
[1.1.4.1.5.4.2.2.5]
b. 17 Jul 1753 d. 9 Dec 1831
Salley Williams
b. 1760
10
James Angell
[1.1.4.1.5.4.2.2.5.1]
b. Abt 1781 d. 20 Nov 1870
10
Susanna Angell
[1.1.4.1.5.4.2.2.5.2]
b. 12 May 1782 d. 22 May 1837
10
Robert Angell
[1.1.4.1.5.4.2.2.5.3]
b. 15 Mar 1786 d. 14 Nov 1862
10
Anna Angell
[1.1.4.1.5.4.2.2.5.4]
b. Dec 1788 d. 14 Apr 1832
10
Sarah Williams Angell
[1.1.4.1.5.4.2.2.5.5]
b. Abt 12 Feb 1791 d. 20 Jul 1810
10
Elizabeth Williams Angell
[1.1.4.1.5.4.2.2.5.6]
b. Abt 6 May 1793 d. 25 Oct 1810
James Angell
b. 31 May 1731 d. Jun 1806
9
Sally Angell
[1.1.4.1.5.4.2.2.6]
b. 30 Oct 1757
8
Mary Whipple
[1.1.4.1.5.4.2.3]
b. Abt 1729 d. 12 Sep 1805
8
Commodore Abraham Whipple
[1.1.4.1.5.4.2.4]
b. 26 Sep 1732 d. 27 May 1819
Sarah Hopkins
b. 26 Sep 1739 d. 14 Oct 1818
9
Catherine Whipple
[1.1.4.1.5.4.2.4.1]
b. Abt 1762 d. 1834
Ebenezer Sproat
b. 9 Feb 1752 d. 29 Aug 1819
10
Sarah Whipple Sproat
[1.1.4.1.5.4.2.4.1.1]
b. 28 Jan 1782 d. 22 Jan 1851
9
Captain John Hopkins Whipple
[1.1.4.1.5.4.2.4.2]
b. 2 Jul 1765
9
Mary Whipple
[1.1.4.1.5.4.2.4.3]
b. Abt 1767 d. 15 Aug 1831
Ezekiel Comstock
b. 17 Jan 1762 d. Abt 27 Feb 1828
10
Elizabeth Carter Comstock
[1.1.4.1.5.4.2.4.3.1]
b. 1792 d. 29 Sep 1822
10
Sarah Ann Comstock
[1.1.4.1.5.4.2.4.3.2]
b. 21 Jan 1795 d. 29 Sep 1854
10
William Whipple Comstock
[1.1.4.1.5.4.2.4.3.3]
b. 23 Mar 1801 d. 20 Oct 1878
8
Samuel Whipple
[1.1.4.1.5.4.2.5]
b. Abt 1740 d. 6 Feb 1827
Elizabeth Snow
b. 28 Sep 1739 d. 22 Sep 1806
9
Noah Whipple
[1.1.4.1.5.4.2.5.1]
b. 15 Feb 1772
9
Samuel Whipple, Jr
[1.1.4.1.5.4.2.5.2]
b. 4 Jul 1774 d. 9 Nov 1843
Mary Chaffee
b. 1779 d. 12 Mar 1828
10
Lucy A Whipple
[1.1.4.1.5.4.2.5.2.1]
b. 4 May 1800 d. 18 Apr 1887
10
John N Whipple
[1.1.4.1.5.4.2.5.2.2]
b. 1801 d. 29 Dec 1865
10
Joseph H Whipple
[1.1.4.1.5.4.2.5.2.3]
b. 3 May 1803 d. 1 Aug 1891
10
Sarepta Whipple
[1.1.4.1.5.4.2.5.2.4]
b. 16 Aug 1808 d. 5 Nov 1840
10
Sabrina Whipple
[1.1.4.1.5.4.2.5.2.5]
b. 1808 d. 1900
+
Gurdon Barrows
b. 26 Feb 1796 d. 23 Aug 1877
10
Reuben Chaffee Whipple
[1.1.4.1.5.4.2.5.2.6]
b. 1809 d. 21 Jan 1828
10
Jonathan C Whipple
[1.1.4.1.5.4.2.5.2.7]
b. 1811
10
Mary Ann Whipple
[1.1.4.1.5.4.2.5.2.8]
b. 1814
10
Samuel A Whipple
[1.1.4.1.5.4.2.5.2.9]
b. 1815 d. 1886
10
Gustavus A Whipple
[1.1.4.1.5.4.2.5.2.10]
b. 1816
10
Elizabeth S Whipple
[1.1.4.1.5.4.2.5.2.11]
b. 1822
10
Martha B Whipple
[1.1.4.1.5.4.2.5.2.12]
b. 1823 d. 1894
9
Sarah Whipple
[1.1.4.1.5.4.2.5.3]
b. 1776 d. 21 Jan 1824
Aaron Rice
b. 11 Nov 1768 d. 11 Jul 1822
10
Samuel Rice
[1.1.4.1.5.4.2.5.3.1]
b. 20 Apr 1798 d. 10 Oct 1892
10
Harvey Rice
[1.1.4.1.5.4.2.5.3.2]
b. 1800 d. 23 Sep 1848
10
Harriet Rice
[1.1.4.1.5.4.2.5.3.3]
b. 13 Aug 1805 d. 31 Mar 1867
10
Roxanna Rice
[1.1.4.1.5.4.2.5.3.4]
b. 1808
10
Sabrina Celestina Rice
[1.1.4.1.5.4.2.5.3.5]
b. 1810 d. 1863
10
Sally Rice
[1.1.4.1.5.4.2.5.3.6]
b. 1811
10
Willard Rice
[1.1.4.1.5.4.2.5.3.7]
b. 1812
10
Sarah Rice
[1.1.4.1.5.4.2.5.3.8]
b. 1814 d. 22 Apr 1833
10
Anna Rice
[1.1.4.1.5.4.2.5.3.9]
b. 1816
9
Hopestill Whipple
[1.1.4.1.5.4.2.5.4]
b. 3 Oct 1778 d. 21 Mar 1860
7
John Dexter
[1.1.4.1.5.4.3]
b. 1701 d. 29 Aug 1780
Mary Brown
b. 30 Jul 1699 d. Aft 1730
8
Mary Dexter
[1.1.4.1.5.4.3.1]
b. 1725
8
Lydia Dexter
[1.1.4.1.5.4.3.2]
b. 18 Jul 1729 d. 21 Aug 1791
8
Jonathan Dexter
[1.1.4.1.5.4.3.3]
b. 4 Aug 1739 d. 31 Jul 1819
Alice Low
b. 1741 d. 1 Sep 1831
9
Mary Dexter
[1.1.4.1.5.4.3.3.1]
b. 1762
9
Philip Dexter
[1.1.4.1.5.4.3.3.2]
b. 1766
9
Joseph Dexter
[1.1.4.1.5.4.3.3.3]
b. 1764
9
Elizabeth Dexter
[1.1.4.1.5.4.3.3.4]
b. 1768
9
Christopher Dexter
[1.1.4.1.5.4.3.3.5]
b. 1770 d. Aft 1811
Betsey Whipple
b. 9 Jan 1768 d. Aft 1811
10
Anthony Dexter
[1.1.4.1.5.4.3.3.5.1]
b. 1791
Mary Ann Dexter
b. 1791 d. 13 Dec 1851
11
Elsie Dexter
[1.1.4.1.5.4.3.3.5.1.1]
b. 1817
11
Abby Dexter
[1.1.4.1.5.4.3.3.5.1.2]
b. 1819
11
Albert Dexter
[1.1.4.1.5.4.3.3.5.1.3]
b. 1821
Mary Cobb
b. 1822
12
Mary Dexter
[1.1.4.1.5.4.3.3.5.1.3.1]
b. 1845
11
Louisa Dexter
[1.1.4.1.5.4.3.3.5.1.4]
b. 1825
11
Adaline Dexter
[1.1.4.1.5.4.3.3.5.1.5]
b. 1827
11
Mary Dexter
[1.1.4.1.5.4.3.3.5.1.6]
b. 1828
10
Susan Dexter
[1.1.4.1.5.4.3.3.5.2]
b. 1793
10
Amy Dexter
[1.1.4.1.5.4.3.3.5.3]
b. 1796
10
Mary Dexter
[1.1.4.1.5.4.3.3.5.4]
b. Abt 1799 d. 30 May 1937
Lodowick Walcott
b. 27 Sep 1795 d. 22 Feb 1841
11
Charles Stuart Walcott
[1.1.4.1.5.4.3.3.5.4.1]
b. 13 Jul 1826 d. 6 Apr 1871
Mary Catherine Leary
b. 5 May 1850 d. 28 Apr 1913
12
Mary Dexter Walcott
[1.1.4.1.5.4.3.3.5.4.1.1]
b. 22 May 1868 d. 1932
12
Gregory Dexter Walcott
[1.1.4.1.5.4.3.3.5.4.1.2]
b. 29 Aug 1869
11
William Henry Walcott
[1.1.4.1.5.4.3.3.5.4.2]
b. 9 Jul 1828 d. 30 Aug 1901
Georgie Josephine Weaver
b. 21 Jan 1852 d. 28 Mar 1926
12
Clinton D S Walcott
[1.1.4.1.5.4.3.3.5.4.2.1]
b. 19 Jun 1873
12
Maude V Peyton Walcott
[1.1.4.1.5.4.3.3.5.4.2.2]
b. 28 Dec 1874
12
Blanche D R Walcott
[1.1.4.1.5.4.3.3.5.4.2.3]
b. 27 May 1876
12
William H L Walcott
[1.1.4.1.5.4.3.3.5.4.2.4]
b. 11 Nov 1879
12
George D Walcott
[1.1.4.1.5.4.3.3.5.4.2.5]
b. Jul 1886
12
Amy Dexter Walcott
[1.1.4.1.5.4.3.3.5.4.2.6]
b. Sep 1888 d. Sep 1888
12
Georgia Dexter Walcott
[1.1.4.1.5.4.3.3.5.4.2.7]
b. Sep 1888 d. Sep 1888
10
Betsey Dexter
[1.1.4.1.5.4.3.3.5.5]
b. 18 Mar 1803
Orin Smith
11
Joseph Orville Smith
[1.1.4.1.5.4.3.3.5.5.1]
b. 1843 d. 1920
10
Maria Dexter
[1.1.4.1.5.4.3.3.5.6]
b. 1805
10
Christopher C Dexter
[1.1.4.1.5.4.3.3.5.7]
b. 1807
10
Caroline Dexter
[1.1.4.1.5.4.3.3.5.8]
b. Abt 1812 d. 6 Jun 1866
Christopher Whipple Kelly
b. 1811 d. 30 Mar 1858
11
Mary Kelly
[1.1.4.1.5.4.3.3.5.8.1]
b. 27 Feb 1832 d. 10 Sep 1906
Edward Cooke
b. 28 May 1836 d. 14 Oct 1897
12
Abigail Whipple Cooke
[1.1.4.1.5.4.3.3.5.8.1.1]
b. 1862 d. 6 Jul 1919
11
George D Kelly
[1.1.4.1.5.4.3.3.5.8.2]
b. 1835 d. 19 Feb 1891
Mary Ann Mathewson
b. Abt 1838 d. 6 Aug 1889
12
Abby Burton Kelley
[1.1.4.1.5.4.3.3.5.8.2.1]
b. 13 Mar 1864 d. 21 May 1875
12
George D Kelly, Jr
[1.1.4.1.5.4.3.3.5.8.2.2]
b. 1866 d. 23 Sep 1875
11
Anna Kelly
[1.1.4.1.5.4.3.3.5.8.3]
b. 1835 d. 1 Jan 1905
William Henry Congdon
b. 1828 d. 27 Jul 1878
12
William Rhodes Congdon
[1.1.4.1.5.4.3.3.5.8.3.1]
b. 22 May 1872 d. 1920 [
=>
]
12
Helena Florence Congdon
[1.1.4.1.5.4.3.3.5.8.3.2]
b. 7 May 1876
11
Caroline Dexter Kelly
[1.1.4.1.5.4.3.3.5.8.4]
b. 1848 d. 16 Mar 1935
9
Abigail Dexter
[1.1.4.1.5.4.3.3.6]
b. 1772
9
Sarah Dexter
[1.1.4.1.5.4.3.3.7]
b. 1776
9
Lydia Dexter
[1.1.4.1.5.4.3.3.8]
b. 1778 d. 10 May 1838
9
John Dexter
[1.1.4.1.5.4.3.3.9]
b. 29 Aug 1780 d. 27 Aug 1840
9
Anne Nancy Dexter
[1.1.4.1.5.4.3.3.10]
b. 1782
Captain Sterry Jenckes
b. 6 Feb 1787 d. 26 Nov 1853
10
Horatio Nelson Jenckes
[1.1.4.1.5.4.3.3.10.1]
b. 8 Aug 1810 d. 30 Dec 1828
10
Elcy Ann Jenckes
[1.1.4.1.5.4.3.3.10.2]
b. 3 Sep 1813 d. 12 Dec 1828
10
Jabez Walcott Jenckes
[1.1.4.1.5.4.3.3.10.3]
b. 7 Jan 1815 d. 11 Jan 1883
10
Rhoda Ann Jenckes
[1.1.4.1.5.4.3.3.10.4]
b. 15 Jan 1818 d. 7 Aug 1847
Levi Carpenter
b. 28 Oct 1803 d. 22 May 1876
11
George Nelson Carpenter
[1.1.4.1.5.4.3.3.10.4.1]
b. 12 Oct 1836 d. 8 Apr 1839
11
Adeline Dexter Carpenter
[1.1.4.1.5.4.3.3.10.4.2]
b. 11 Mar 1838
Rufus Waterman
b. 10 Feb 1831 d. 19 Apr 1885
12
Richard Waterman
[1.1.4.1.5.4.3.3.10.4.2.1]
b. 15 Oct 1857
11
Rebecca Sheldon Carpenter
[1.1.4.1.5.4.3.3.10.4.3]
b. 6 Jun 1840 d. 17 Jul 1921
Richard Waterman
b. 13 Mar 1834 d. 11 Mar 1925
12
Elisha Amaziah Waterman
[1.1.4.1.5.4.3.3.10.4.3.1]
b. 16 Jul 1858 d. 2 Feb 1931
12
Elsie Carpenter Waterman
[1.1.4.1.5.4.3.3.10.4.3.2]
b. 18 Jan 1866 d. 15 May 1913
12
Byron Levi Waterman
[1.1.4.1.5.4.3.3.10.4.3.3]
b. 14 Mar 1870 d. 1964 [
=>
]
11
Elsie Jenks Carpenter
[1.1.4.1.5.4.3.3.10.4.4]
b. 5 Mar 1842
11
Charley Carpenter
[1.1.4.1.5.4.3.3.10.4.5]
b. 27 Jan 1847 d. 28 Nov 1872
10
Diana Jenckes
[1.1.4.1.5.4.3.3.10.5]
b. 7 Apr 1820 d. 4 Mar 1890
10
Albert Cheney Jenckes
[1.1.4.1.5.4.3.3.10.6]
b. 16 Mar 1822 d. 22 Dec 1887
10
Mary Humphry Jenckes
[1.1.4.1.5.4.3.3.10.7]
b. 24 Jan 1824 d. 17 Mar 1914
10
Charles Erastus Jenckes
[1.1.4.1.5.4.3.3.10.8]
b. 10 Oct 1825 d. 7 Apr 1896
10
Ardelia Jenckes
[1.1.4.1.5.4.3.3.10.9]
b. 9 Sep 1827 d. 8 Sep 1925
10
Henry Hartwell Jenckes
[1.1.4.1.5.4.3.3.10.10]
b. 14 Aug 1829
10
Nathaniel Miles Jenckes
[1.1.4.1.5.4.3.3.10.11]
b. 28 Aug 1831 d. 5 Jul 1892
10
George F Jenckes
[1.1.4.1.5.4.3.3.10.12]
b. 7 May 1834 d. 27 May 1922
9
Alice L Dexter
[1.1.4.1.5.4.3.3.11]
b. Abt 1768 d. 27 Sep 1863
7
Sarah Dexter
[1.1.4.1.5.4.4]
b. Apr 1703 d. 30 Oct 1779
Captain Solomon Smith
b. 4 Mar 1702 d. 25 Mar 1771
8
Ezekiel Smith
[1.1.4.1.5.4.4.1]
b. 13 Mar 1726 d. 18 Jul 1777
8
Mercy Smith
[1.1.4.1.5.4.4.2]
b. 12 Jan 1727 d. 4 Jan 1776
John Winsor
b. 2 Mar 1723 d. 30 Mar 1808
9
Stephen Winsor
[1.1.4.1.5.4.4.2.1]
b. 14 Dec 1744 d. 14 Jan 1820
9
Sarah Winsor
[1.1.4.1.5.4.4.2.2]
b. 4 Jun 1746 d. 1797
John Smith
b. 14 Feb 1740 d. 31 Mar 1798
10
Thankful Smith
[1.1.4.1.5.4.4.2.2.1]
b. 11 Jan 1763 d. Jul 1860
10
Cyna Smith
[1.1.4.1.5.4.4.2.2.2]
b. 7 Sep 1765 d. 11 Jan 1776
10
Mercy Smith
[1.1.4.1.5.4.4.2.2.3]
b. 30 Nov 1770
James Olney
b. 21 Mar 1772 d. 25 Jul 1820
11
Mahaila Olney
[1.1.4.1.5.4.4.2.2.3.1]
b. 15 Oct 1791 d. 2 Aug 1880
Alvah Smith
b. 15 Jun 1794 d. 22 Nov 1842
12
James O Smith
[1.1.4.1.5.4.4.2.2.3.1.1]
b. 1820 [
=>
]
12
Lucina Smith
[1.1.4.1.5.4.4.2.2.3.1.2]
b. 1822
12
Rhoda H Smith
[1.1.4.1.5.4.4.2.2.3.1.3]
b. 1824
12
Edwin F Smith
[1.1.4.1.5.4.4.2.2.3.1.4]
b. 1830 [
=>
]
11
Nancy Olney
[1.1.4.1.5.4.4.2.2.3.2]
b. 18 Apr 1795 d. 23 Oct 1874
Smith Wood
b. 7 Oct 1799 d. 26 May 1867
12
Emeline Maria Wood
[1.1.4.1.5.4.4.2.2.3.2.1]
b. 23 Sep 1821
12
Emor Smith Wood
[1.1.4.1.5.4.4.2.2.3.2.2]
b. 3 May 1823
11
John Olney
[1.1.4.1.5.4.4.2.2.3.3]
b. 1 May 1798
Amey Wood
b. 24 Mar 1803 d. 7 Mar 1863
12
Sarah Olney
[1.1.4.1.5.4.4.2.2.3.3.1]
b. 2 Jun 1824
12
James Winsor Olney
[1.1.4.1.5.4.4.2.2.3.3.2]
b. 18 Jun 1826 [
=>
]
11
Urana Olney
[1.1.4.1.5.4.4.2.2.3.4]
b. Abt 1809 d. 1875
10
Samuel Smith
[1.1.4.1.5.4.4.2.2.4]
b. Abt 1770 d. 14 Sep 1813
10
Eber Smith
[1.1.4.1.5.4.4.2.2.5]
b. 10 May 1773 d. 26 May 1844
10
Zenas Smith
[1.1.4.1.5.4.4.2.2.6]
b. 5 Jun 1775
10
Mary Smith
[1.1.4.1.5.4.4.2.2.7]
b. 30 Jul 1778 d. 6 May 1843
9
Providence Winsor
[1.1.4.1.5.4.4.2.3]
b. 3 Dec 1747 d. Aug 1778
9
Joshua Winsor
[1.1.4.1.5.4.4.2.4]
b. 19 Jan 1749 d. 19 Jan 1770
9
Ruth Winsor
[1.1.4.1.5.4.4.2.5]
b. 18 May 1751
9
Alice Winsor
[1.1.4.1.5.4.4.2.6]
b. 12 Jan 1753 d. 4 Jan 1785
9
Deborah Winsor
[1.1.4.1.5.4.4.2.7]
b. 31 Mar 1756 d. 3 Apr 1815
9
Candace Winsor
[1.1.4.1.5.4.4.2.8]
b. 1 Feb 1758 d. 1846
9
Thomas Winsor
[1.1.4.1.5.4.4.2.9]
b. 21 Oct 1759 d. 25 Feb 1798
9
Mercy Ann Winsor
[1.1.4.1.5.4.4.2.10]
b. 5 Aug 1761 d. 13 Sep 1813
9
Zilpha Winsor
[1.1.4.1.5.4.4.2.11]
b. 1 Apr 1763 d. 18 Jun 1773
9
Cynthia Winsor
[1.1.4.1.5.4.4.2.12]
b. 20 May 1765 d. 1847
9
Lydia Winsor
[1.1.4.1.5.4.4.2.13]
b. 1 Jan 1767 d. Aft 1806
8
Captain John S Smith
[1.1.4.1.5.4.4.3]
b. 20 Jan 1730 d. 7 May 1828
8
William Smith
[1.1.4.1.5.4.4.4]
b. 5 Mar 1732 d. 3 Jul 1736
8
Sarah Smith
[1.1.4.1.5.4.4.5]
b. 4 May 1734
8
Anphillis Smith
[1.1.4.1.5.4.4.6]
b. 4 Oct 1736
8
Ruth Smith
[1.1.4.1.5.4.4.7]
b. May 1739
8
Naomi Smith
[1.1.4.1.5.4.4.8]
b. 3 May 1741 d. Mar 1794
8
Mary Smith
[1.1.4.1.5.4.4.9]
b. 24 Dec 1742
8
Margaret Smith
[1.1.4.1.5.4.4.10]
b. 1744 d. Mar 1794
7
Stephen Dexter
[1.1.4.1.5.4.5]
b. 1703 d. 1 Oct 1741
7
Jeremiah Dexter
[1.1.4.1.5.4.6]
b. 1705
7
Lydia Dexter
[1.1.4.1.5.4.7]
b. 1709
7
William Dexter
[1.1.4.1.5.4.8]
b. 1711
7
Abigail Dexter
[1.1.4.1.5.4.9]
b. 1712 d. 13 Dec 1792
7
Jonathan Dexter
[1.1.4.1.5.4.10]
b. 1713
6
Thomas Field, Jr
[1.1.4.1.5.5]
b. 3 Jan 1670 d. 17 Jul 1752
Abigail Dexter
b. Abt 1675 d. Aft 19 Aug 1725
7
Thomas Field III
[1.1.4.1.5.5.1]
b. 1696 d. 20 May 1777
7
Joseph Field
[1.1.4.1.5.5.2]
b. 1699 d. 5 Oct 1736
7
Stephen Field
[1.1.4.1.5.5.3]
b. Abt 1700 d. 10 Sep 1727
7
Jeremiah Field
[1.1.4.1.5.5.4]
b. 1706 d. 2 Sep 1768
7
Nathaniel Field
[1.1.4.1.5.5.5]
b. 1708 d. 3 Jan 1753
7
Anthony Field
[1.1.4.1.5.5.6]
b. 1712 d. 19 Apr 1762
+
Abigail Chaffe
b. Abt 1689 d. Aft 1753
6
Martha Field
[1.1.4.1.5.6]
b. 1683 d. 1735
5
Margaret Harris
[1.1.4.1.6]
b. 1643 d. 2 Apr 1659
2
Jarvis Austin
[1.2]
b. 16 Jul 1554 d. 5 Jun 1610
2
Mykaell Austin
[1.3]
b. 4 Dec 1555 bur. 25 Dec 1555
2
Margareta Austin
[1.4]
b. 15 Mar 1557 d. 22 May 1566
2
Margery Austin
[1.5]
b. 26 Mar 1557 d. 13 Jan 1566
2
Michael Austin
[1.6]
c. 19 Feb 1559