Home Page
|
What's New
|
Photos
|
Histories
|
Headstones
|
Reports
|
Surnames
Search
First Name:
Last Name:
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Suomalainen
Svenska
Abraham Humbert
Abt 1624 -
Submit Photo / Document
Individual
Descendants
Relationship
Timeline
Submit Photo / Doc
Worksheet
Family
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Abraham Humbert
[1]
b. Abt 1624
Mrs Humbert
b. 1628
2
Jacquemaz Humbert
[1.1]
b. 14 Dec 1656
Francois Thury
b. Abt 1652
3
Paul Thury
[1.1.1]
c. 15 May 1693 d. Abt 1750
Jean Claudine DuCloz
b. Abt 1685 d. 22 Jan 1769
4
Charles Thury
[1.1.1.1]
c. 1716 d. 24 Sep 1759
+
Jeanne Chamblard
b. Abt 1716
4
Jeanne Elizabeth Thury
[1.1.1.2]
c. 18 Jan 1718 d. 15 Nov 1768
+
Jean Pierre Moinat
b. Abt 1718
4
Benenigne Thury
[1.1.1.3]
c. 10 Mar 1720
Pierre David Moinat
b. Abt 1723 d. 18 Aug 1800
5
Francoise Samuel Oliver Moinat
[1.1.1.3.1]
b. 25 Mar 1742 d. 26 Mar 1742
5
Jean Marc Moinat
[1.1.1.3.2]
b. 19 May 1743
5
Jeanne Louise Moinat
[1.1.1.3.3]
b. 3 Jan 1745
5
Jeanne Louise Catherine Moinat
[1.1.1.3.4]
b. 10 Apr 1746
5
Rose Louise Moinat
[1.1.1.3.5]
b. 15 Jun 1749 d. 30 Sep 1767
5
Jeanne Marie Moinat
[1.1.1.3.6]
b. 8 Jul 1753
5
Jean Charles Moinat
[1.1.1.3.7]
b. 23 Nov 1755 d. 20 Oct 1816
Anne Elizabe Stoudeman
c. 27 Jun 1756 d. 7 Dec 1826
6
Henri Louis Moinat
[1.1.1.3.7.1]
c. 1 Feb 1781 d. 12 Feb 1781
6
Jeanne Marianne Moinat
[1.1.1.3.7.2]
b. 30 Oct 1784 d. 15 Nov 1834
Noe David Benedict LeCoultre
b. 10 Nov 1775 d. 11 Jan 1836
7
Louise Charlotte LeCoultre
[1.1.1.3.7.2.1]
b. 17 Aug 1804 d. 27 Dec 1865
7
Louise Josephine LeCoultre
[1.1.1.3.7.2.2]
b. 11 Jan 1807
7
Frederic Philippe Jacques LeCoultre
[1.1.1.3.7.2.3]
b. 16 Sep 1808 d. 3 Jul 1816
7
Paul Frederic LeCoultre
[1.1.1.3.7.2.4]
b. 17 Aug 1810 d. 24 Nov 1811
7
Catherine Louise Anne Susette LeCoultre
[1.1.1.3.7.2.5]
b. 27 Oct 1812 d. 1883
7
Alexandre Francois LeCoultre
[1.1.1.3.7.2.6]
b. 13 Oct 1815
7
Samuel Alphonse Louis LeCoultre
[1.1.1.3.7.2.7]
b. 10 Oct 1817 d. 7 Feb 1819
7
Elise Marie LeCoultre
[1.1.1.3.7.2.8]
b. 24 Nov 1824 d. 13 May 1872
Serge Louis Ballif
b. 17 Apr 1821 d. 25 Apr 1901
8
Louisa Alexandrine Ballif
[1.1.1.3.7.2.8.1]
b. 25 Feb 1850 d. 7 Feb 1922
George Taft Benson
b. 1 May 1846 d. 16 May 1919
9
Louisa "Lulu" Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.1]
b. 28 Mar 1869 d. 15 Jul 1938
William Chandler Parkinson
b. 2 Aug 1855 d. 18 Nov 1929
10
Louisa Benson Parkinson
[1.1.1.3.7.2.8.1.1.1]
b. 5 Jul 1889 d. 12 Sep 1973
Curtis Young Clawson
b. 27 Jul 1884 d. 5 Aug 1941
11
Nabbie Louise Clawson
[1.1.1.3.7.2.8.1.1.1.1]
b. 5 Apr 1912 d. 16 Jan 1992
Soren Morgan Sorensen
b. 13 Jan 1912 d. 9 Sep 1989
12
Sally Louise Sorensen
[1.1.1.3.7.2.8.1.1.1.1.1]
b. 5 Feb 1935 d. 6 Dec 1987
12
Steven Morgan Sorensen
[1.1.1.3.7.2.8.1.1.1.1.2]
b. 11 Jan 1937 d. 18 Nov 2020
+
Roland Green Lett
b. 31 Mar 1909 d. 18 Mar 1988
11
Jeannette Clawson
[1.1.1.3.7.2.8.1.1.1.2]
b. 16 Apr 1914 d. 26 Nov 1983
Edward Charles Judd
b. 13 Apr 1916 d. 29 Dec 2004
12
Curtis Clawson Judd
[1.1.1.3.7.2.8.1.1.1.2.1]
b. 22 Sep 1941 d. 12 Oct 1976
12
Edward Clawson Judd
[1.1.1.3.7.2.8.1.1.1.2.2]
b. 22 May 1953 d. 22 May 1953
12
Mary Alice Judd
[1.1.1.3.7.2.8.1.1.1.2.3]
b. 6 Feb 1955 d. 6 Feb 1955
11
William Curtis Clawson
[1.1.1.3.7.2.8.1.1.1.3]
b. 12 Dec 1919 d. 22 Oct 1997
+
Donette Elizabeth Bosworth
b. 10 Jan 1914 d. 1 Apr 1988
10
Marie Benson Parkinson
[1.1.1.3.7.2.8.1.1.2]
b. 13 Dec 1891 d. 22 Jan 1919
10
Charlotte Benson Parkinson
[1.1.1.3.7.2.8.1.1.3]
b. 16 Jul 1894 d. 13 Oct 1980
10
Clara Parkinson
[1.1.1.3.7.2.8.1.1.4]
b. 8 Aug 1897 d. 6 Oct 1992
Franklin Ross Anderson
b. 28 Jun 1897 d. 22 Jul 1957
11
Clara Jean Anderson
[1.1.1.3.7.2.8.1.1.4.1]
b. 3 Feb 1919 d. 17 Sep 1994
11
Kathryn Anderson
[1.1.1.3.7.2.8.1.1.4.2]
b. 3 Mar 1922 d. 13 Mar 2000
+
Robert Preston Caine
b. 30 Jun 1920 d. 10 Feb 1994
10
George Benson Parkinson
[1.1.1.3.7.2.8.1.1.5]
b. 17 Oct 1899 d. 31 Oct 1918
10
Adeline Parkinson
[1.1.1.3.7.2.8.1.1.6]
b. 2 Jan 1902 d. 27 Apr 1990
George Lloyd Wyman
b. 16 Sep 1895 d. 4 Dec 1969
11
Patricia Ann Wyman
[1.1.1.3.7.2.8.1.1.6.1]
b. 13 Nov 1940 d. 17 Apr 2000
10
Wilbur Chandler Parkinson
[1.1.1.3.7.2.8.1.1.7]
b. 10 Oct 1904 d. 20 Dec 1988
Darlene Gladys Stevenson
b. 12 Jan 1902 d. 20 Mar 1986
11
Living
[1.1.1.3.7.2.8.1.1.7.1]
11
Living
[1.1.1.3.7.2.8.1.1.7.2]
10
Carmen Parkinson
[1.1.1.3.7.2.8.1.1.8]
b. 5 Oct 1907 d. 24 Mar 1993
Charles Jacob Brock
b. 28 Jan 1907 d. 13 Jun 1966
11
Janice Brock
[1.1.1.3.7.2.8.1.1.8.1]
b. 12 Dec 1929 d. 20 Jul 2009
+
John Richard Cooper
b. 20 Feb 1928 d. 25 Apr 1995
11
Joanne Brock
[1.1.1.3.7.2.8.1.1.8.2]
b. 12 Dec 1929 d. 26 Aug 2011
12
Tonja Rigby
[1.1.1.3.7.2.8.1.1.8.2.1]
b. 24 Jan 1955 d. 27 Jun 1995
11
Charles Richard Brock
[1.1.1.3.7.2.8.1.1.8.3]
b. 26 Jun 1931 d. 23 Aug 1941
11
Patricia Brock
[1.1.1.3.7.2.8.1.1.8.4]
b. 18 Oct 1937 d. 11 Mar 2015
10
Evelyn Parkinson
[1.1.1.3.7.2.8.1.1.9]
b. 30 Mar 1910 d. 30 Jun 1991
+
Max Porter Brown
b. 9 Jan 1908 d. 11 Aug 1991
10
Wanda Parkinson
[1.1.1.3.7.2.8.1.1.10]
b. 31 Jul 1911 d. 13 Jun 1995
Winfield Quayle Cannon
b. 31 Aug 1908 d. 2 Mar 1998
11
Stuart Quayle Cannon
[1.1.1.3.7.2.8.1.1.10.1]
b. 20 Mar 1933 d. 21 Feb 2014
9
Ezra Taft Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.2]
b. 6 Aug 1871 d. 28 Aug 1871
9
Elise Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.3]
b. 10 Mar 1873 d. 22 Aug 1937
George Alfred Alder, Jr
b. 4 Jan 1874 d. 3 May 1940
10
Ione Benson Alder
[1.1.1.3.7.2.8.1.3.1]
b. 9 Jul 1896 d. 6 Oct 1983
Quincy Burt Coray
b. 28 Oct 1895 d. 18 Oct 1985
11
Daughter Coray
[1.1.1.3.7.2.8.1.3.1.1]
b. 11 Jan 1929 d. 11 Jan 1929
10
Lydia Dunford Alder
[1.1.1.3.7.2.8.1.3.2]
b. 30 Nov 1898 d. 7 Aug 1983
+
Leroy Harrison Bean
b. 26 Aug 1889 d. 8 Mar 1957
10
Linden Benson Alder
[1.1.1.3.7.2.8.1.3.3]
b. 20 Mar 1900 d. 8 Aug 1957
Georgia Ellen Payzant
b. 22 Feb 1905 d. 31 Aug 1992
11
Richard Jerome Alder
[1.1.1.3.7.2.8.1.3.3.1]
b. 12 May 1931 d. 12 May 1931
11
Daniel Blaine Alder
[1.1.1.3.7.2.8.1.3.3.2]
b. 25 May 1936 d. 28 May 1936
10
Garold Benson Alder
[1.1.1.3.7.2.8.1.3.4]
b. 2 May 1902 d. 12 Jun 1960
Norma Blake
b. 29 Aug 1904 d. 1 May 1997
11
Lawrence Wesley Alder
[1.1.1.3.7.2.8.1.3.4.1]
b. 28 Dec 1933 d. 9 Jun 2014
10
George Benson Alder
[1.1.1.3.7.2.8.1.3.5]
b. 1 May 1906 d. 11 Nov 1974
Florence Egan
b. 28 Feb 1911 d. 28 Sep 1981
11
David Egan Alder
[1.1.1.3.7.2.8.1.3.5.1]
b. 21 Jan 1935 d. 3 Aug 2014
11
Living
[1.1.1.3.7.2.8.1.3.5.2]
11
Diane Elise Alder
[1.1.1.3.7.2.8.1.3.5.3]
b. 12 Feb 1940 d. 4 Jun 2005
11
Kent Egan Alder
[1.1.1.3.7.2.8.1.3.5.4]
b. 21 Sep 1941 d. 29 Jun 2004
10
Ballif Benson Alder
[1.1.1.3.7.2.8.1.3.6]
b. 1 May 1906 d. 23 Nov 1906
10
Donald Benson Alder
[1.1.1.3.7.2.8.1.3.7]
b. 4 Dec 1908 d. 14 Mar 1993
Elsie Marie Loveland
b. 22 Feb 1914 d. 11 Nov 2003
11
Gordon Jerome Alder
[1.1.1.3.7.2.8.1.3.7.1]
b. 1 Feb 1935 d. 20 Jun 1936
10
George Alfred Alder
[1.1.1.3.7.2.8.1.3.8]
b. 9 Jul 1912 d. 29 Mar 1913
9
George Taft Benson, Jr
[1.1.1.3.7.2.8.1.4]
b. 24 Jun 1875 d. 13 Aug 1934
Sarah Sophia Dunkley
b. 29 Jun 1878 d. 1 Jun 1933
10
Ezra Taft Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.1]
b. 4 Aug 1899 d. 30 May 1994
Flora Smith Amussen
b. 1 Jul 1901 d. 14 Aug 1992
11
Reed Amussen Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.1.1]
b. 2 Jan 1928 d. 24 Aug 2016
Mary May Hinckley
12
Heidi Hinckley Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.1.1.1]
b. 10 Mar 1966 d. 23 Jul 2009 [
=>
]
12
Holly H Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.1.1.2]
12
Taft Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.1.1.3]
12
Heather H Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.1.1.4]
12
M Mark Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.1.1.5]
12
Lucilla H Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.1.1.6]
12
Joshua R Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.1.1.7]
12
Lynna H Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.1.1.8]
12
Sarah D Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.1.1.9]
11
Mark Amussen Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.1.2]
b. 2 May 1929 d. 29 Jul 2012
Lela Wing
b. 17 Apr 1931 d. 29 Sep 2016
12
Living
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.1.2.1]
12
Living
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.1.2.2]
12
Living
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.1.2.3]
12
Living
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.1.2.4]
12
Living
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.1.2.5]
12
Living
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.1.2.6]
11
Barbara Amussen Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.1.3]
b. 20 Jun 1934 d. 26 Mar 2020
Robert Harris Walker
b. 15 Sep 1922 d. 10 May 1998
12
Flora Walker
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.1.3.1]
12
Heather Walker
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.1.3.2]
12
Laurel Walker
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.1.3.3]
12
Robert Walker
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.1.3.4]
12
Holly Walker
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.1.3.5]
11
Beverly Amussen Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.1.4]
11
Bonnie Amussen Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.1.5]
11
Flora Beth Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.1.6]
10
Joseph Dunkley Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.2]
b. 12 Nov 1900 d. 24 Apr 1936
Iva Laura Jones
b. 16 Jun 1905 d. 10 Dec 1978
11
Joe Dell Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.2.1]
b. 18 Jan 1931 d. 13 Sep 1978
+
Aldine Case
b. 30 Nov 1927 d. 27 Jul 2012
11
Colleen Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.2.2]
b. 12 Mar 1929 d. 27 Oct 2006
11
David Keith Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.2.3]
b. 12 Aug 1936 d. 21 Sep 2020
+
Madelin Adelaide Law
b. 17 Jul 1936 d. 31 Oct 2012
10
Margaret Dunkley Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.3]
b. 16 Feb 1902 d. 3 Jul 1999
Rulon Morgan Keller
b. 21 Jan 1901 d. 13 Jan 1970
11
Rulon Benson Keller
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.3.1]
b. 13 Dec 1923 d. 16 Feb 1924
11
Benson James Keller
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.3.2]
b. 29 Jun 1925 d. 7 Feb 1926
11
Mar Rue Keller
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.3.3]
b. 10 Mar 1928 d. 28 Dec 2021
+
Simmons
11
Marco Keller
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.3.4]
b. 26 Sep 1929 d. 2 Nov 2008
+
Seth Fuhriman Forsgren
b. 11 Mar 1925 d. 17 May 2001
11
Sara Beth Keller
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.3.5]
b. 13 Jan 1932 d. 10 May 2009
+
Robert Henry Thompson
b. 18 Mar 1931 d. 24 Feb 2013
11
Lamond Benson Keller
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.3.6]
b. 11 May 1934 d. 31 May 2012
+
Betty Jo Garber
b. 25 Mar 1931 d. 14 May 2010
+
Living
11
Living
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.3.7]
11
Living
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.3.8]
10
Orval Dunkley Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.4]
b. 30 Aug 1903 d. 1 Jul 1991
Lourena May Clayson
b. 7 May 1907 d. 4 May 1997
11
Orval Clayson Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.4.1]
b. 8 Feb 1933 d. 5 Apr 2021
+
Elaine
11
Kent Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.4.2]
b. 2 Dec 1934 d. 4 Jul 1995
Louise Anderson
b. 18 Jun 1943 d. 15 Apr 1965
12
Kathryn Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.4.2.1]
b. 11 Dec 1964 d. 15 Apr 1965
Mary Dawn Keppner
b. 12 May 1936 d. 3 Dec 1988
12
Aaron Johnson Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.4.2.2]
b. 15 Apr 1971 d. 16 Apr 1971
12
Dierdre Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.4.2.3]
b. 7 Jun 1976 d. 8 Jun 1976
11
Mignon Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.4.3]
b. 20 Oct 1936 d. 25 Dec 1936
11
Morris Clayson Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.4.4]
b. 21 Dec 1939 d. 6 Oct 2013
Jean Anne Johnson
12
Laurie Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.4.4.1]
12
Shannon Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.4.4.2]
12
Bonnie Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.4.4.3]
12
Joel Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.4.4.4]
12
Julie Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.4.4.5]
12
Kimball Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.4.4.6]
11
Larry Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.4.5]
+
Lynda
11
Marsha Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.4.6]
+
Del Shumway
11
Vaughn Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.4.7]
+
Cecelia
10
Louisa Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.5]
b. 10 Oct 1905 d. 2 Jul 1996
Quentin Edward Greenwood
b. 8 Apr 1907 d. 6 Feb 1999
11
Donald Greenwood
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.5.1]
11
Janet Greenwood
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.5.2]
b. 11 Apr 1934 d. 2018
+
Living
11
David Greenwood
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.5.3]
11
Evelyn Greenwood
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.5.4]
10
Lera Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.6]
b. 4 May 1907 d. 10 Jun 2009
Cyril Monroe Whittle
b. 26 Sep 1902 d. 15 Apr 1961
11
Sabra Whittle
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.6.1]
b. 19 Jan 1933 d. 1 Feb 2002
Elwood Rey Peterson
b. 25 Jan 1932 d. 20 Aug 1983
12
ElRey Lynn Peterson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.6.1.1]
b. 4 Apr 1955 d. 2 Oct 2006
12
Brett Whittle Peterson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.6.1.2]
b. 21 Aug 1969 d. 16 Apr 1978
11
William Monroe Whittle
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.6.2]
b. 22 Jun 1935 d. 5 Feb 2016
11
George Benson Whittle
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.6.3]
b. 27 Mar 1944 d. 27 Jul 2011
11
Valerie Whittle
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.6.4]
b. 16 Nov 1947 d. 3 Feb 2010
Daniel Joseph Miller
b. 26 Dec 1952 d. 26 May 2007
12
Joseph Garrett Miller
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.6.4.1]
b. 15 Dec 1982 d. 30 Dec 2016
11
Lee Monroe Whittle
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.6.5]
b. Abt 1949 d. 25 Dec 2017
10
Valdo Dunkley Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.7]
b. 23 Apr 1911 d. 30 Oct 1990
Ruth Watkins
b. 12 Oct 1916 d. 7 Feb 2006
11
Lauralie Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.7.1]
11
John Taft Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.7.2]
b. 4 Jan 1944 d. 14 Nov 2019
11
Ralph V Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.7.3]
11
Rebecca Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.7.4]
11
JoAnn Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.7.5]
10
George Taft Benson, III
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.8]
b. 27 Aug 1912 d. 15 Apr 1990
Wilma Maudell "Billie" Harris
b. 25 Nov 1917 d. 16 Nov 1968
11
Mardi Gail Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.8.1]
b. 14 Jun 1941 d. 27 Apr 2015
+
Hill
11
George Taft Benson, IV
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.8.2]
b. 9 Dec 1943 d. 13 Jul 2010
11
Maureen M Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.8.3]
+
Clayton
11
Linda W Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.8.4]
+
Bennett
11
Jacquelyn Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.8.5]
+
Davis
11
Janet W Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.8.6]
+
Kirkham
11
Susan W Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.8.7]
+
Bowen
11
Brian Harris Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.8.8]
+
Venice Pugmire
b. 25 Aug 1916 d. 4 Mar 1971
+
Jane Seare
b. 25 Mar 1917 d. 17 Apr 2011
10
Sarah Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.9]
b. 30 Sep 1914 d. 26 Sep 2001
Achton Christian Jensen
b. 24 Dec 1904 d. 21 Aug 1978
11
Jerry Wayne Jensen
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.9.1]
b. 19 Mar 1938 d. 6 Aug 2012
+
Thomas Eben Eveleth
b. 20 Jan 1914 d. 15 Nov 2003
10
Ross Dean Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.10]
b. 20 Jan 1917 d. 23 Oct 1985
+
Barbara Jean White
b. 11 Jul 1920 d. 25 Feb 2004
10
Volco Ballif Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.4.11]
b. 11 Apr 1920 d. 13 Mar 1992
+
Helen Anderson
b. 21 Apr 1919 d. 4 Feb 1999
+
Clara Maria Danielsen
b. 10 Feb 1892 d. 20 Oct 1958
9
Serge Ballif Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.5]
b. 2 Oct 1877 d. 18 Jan 1959
Melinda Caroline Nelson
b. 8 Sep 1881 d. 27 Jun 1971
10
Sergene Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.5.1]
b. 7 Aug 1904 d. 23 Jun 1995
Frank Charles Simmons
b. 23 Jan 1904 d. 1 Apr 1990
11
Linda Lou Simmons
[1.1.1.3.7.2.8.1.5.1.1]
b. 12 Apr 1937 d. 24 May 1948
11
Serge Benson Simmons
[1.1.1.3.7.2.8.1.5.1.2]
b. 4 Mar 1944 d. 2 Nov 1969
12
Chantile Melinda Simmons
[1.1.1.3.7.2.8.1.5.1.2.1]
b. 2 Sep 1963 d. 6 Jun 1997
10
Serge Nelson Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.5.2]
b. 15 Mar 1906 d. 28 Oct 1994
Elizabeth Ruth Horton
b. 1 Oct 1906 d. 15 May 1994
11
Sergene Elizabeth Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.5.2.1]
b. 5 Apr 1932 d. 16 Oct 2014
11
Donna Louise Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.5.2.2]
b. 17 Apr 1938 d. 9 Dec 2011
10
Constance Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.5.3]
b. 24 Apr 1908 d. 23 Jul 1981
Julius Veggo Madsen
b. 16 May 1899 d. 15 Jun 1981
11
Connie Marie Madsen
[1.1.1.3.7.2.8.1.5.3.1]
b. 11 Jul 1930 d. 27 Jul 2007
+
Arthur Dixon Terry
b. 27 Jan 1928 d. 3 Jan 2013
11
Franklin Benson Madsen
[1.1.1.3.7.2.8.1.5.3.2]
b. 19 Jul 1934 d. 4 Apr 2011
10
Donna Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.5.4]
b. 16 Mar 1910 d. 5 Dec 1997
Lawrence Lee
b. 26 Jan 1903 d. 5 Jun 1976
11
Lawrence Benson Lee
[1.1.1.3.7.2.8.1.5.4.1]
b. 8 Dec 1931 d. 7 Jun 2014
11
Karen Louise Lee
[1.1.1.3.7.2.8.1.5.4.2]
b. 12 Dec 1933 d. 27 Mar 2005
11
Patricia Fae Lee
[1.1.1.3.7.2.8.1.5.4.3]
b. 17 Jan 1937 d. 30 Jun 2017
11
Zetta Maurie Lee
[1.1.1.3.7.2.8.1.5.4.4]
b. 18 Sep 1938 d. 10 Nov 1985
12
Ticia Lauri Hartman
[1.1.1.3.7.2.8.1.5.4.4.1]
b. 19 Dec 1969 d. 10 Nov 1985
10
Fae Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.5.5]
b. 14 Feb 1914 d. 9 Oct 1968
+
Wayne Jay Hansen
b. 28 Jan 1910 d. 22 Jun 1948
+
Mark Hamp Low
b. 23 Aug 1907 d. 5 Aug 1981
10
Zetta Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.5.6]
b. 20 Aug 1916 d. 6 Sep 2013
Edwin Loose Peterson
b. 27 Oct 1915 d. 19 Aug 1999
11
Living
[1.1.1.3.7.2.8.1.5.6.1]
11
Lizette Peterson
[1.1.1.3.7.2.8.1.5.6.2]
b. 24 Feb 1951 d. 18 Jul 2002
11
Edwina Peterson
[1.1.1.3.7.2.8.1.5.6.3]
10
Theodore Nelson Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.5.7]
b. 1 Apr 1919 d. 27 Jan 2006
Margaret Jayne Todd
11
Kristen Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.5.7.1]
11
Elizabeth Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.5.7.2]
11
Carolinda Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.5.7.3]
10
Jacqueline Maurie Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.5.8]
b. 17 May 1925 d. 23 Apr 2019
+
Jay Richard Bell
b. 24 Jul 1925 d. 25 Mar 2010
9
Adeline Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.6]
b. 31 Jul 1879 d. 27 Jan 1960
Leo Peck
b. 28 Jun 1875 d. 12 Oct 1967
10
Florence Peck
[1.1.1.3.7.2.8.1.6.1]
b. 1 May 1901 d. 23 Apr 1991
Grant Parkinson Packer
b. 12 Mar 1898 d. 23 Mar 1981
11
Grant Peck Packer
[1.1.1.3.7.2.8.1.6.1.1]
b. 21 May 1925 d. 2 Jun 2008
Beverly White
b. 27 Mar 1930 d. 17 Dec 2010
12
Durel Peck Packer
[1.1.1.3.7.2.8.1.6.1.1.1]
b. 3 Aug 1959 d. 6 Apr 1970
12
Wendy Packer
[1.1.1.3.7.2.8.1.6.1.1.2]
b. 11 Sep 1962 d. 27 Jul 1967
11
Leo Benson Packer
[1.1.1.3.7.2.8.1.6.1.2]
b. 13 Nov 1927 d. 29 May 1974
12
Julie Packer
[1.1.1.3.7.2.8.1.6.1.2.1]
b. 17 Sep 1949 d. 18 Sep 1949
12
Kevin Lee Packer
[1.1.1.3.7.2.8.1.6.1.2.2]
b. 1 Jan 1952 d. 5 Oct 1963
12
Kim B Packer
[1.1.1.3.7.2.8.1.6.1.2.3]
b. 23 Feb 1953 d. 23 Feb 1953
12
Brian Packer
[1.1.1.3.7.2.8.1.6.1.2.4]
b. 9 Dec 1960 d. 10 Dec 1960
11
Margaret Catherine Packer
[1.1.1.3.7.2.8.1.6.1.3]
b. 16 Aug 1930 d. 26 Nov 2015
11
Ossian Leonidas Packer
[1.1.1.3.7.2.8.1.6.1.4]
b. 8 Dec 1932 d. 17 Aug 2015
11
Don Peck Packer
[1.1.1.3.7.2.8.1.6.1.5]
11
Maurine Peck Packer
[1.1.1.3.7.2.8.1.6.1.6]
b. 7 May 1940 d. 18 Apr 1995
11
David Packer
[1.1.1.3.7.2.8.1.6.1.7]
11
Carla Rae Packer
[1.1.1.3.7.2.8.1.6.1.8]
10
Effie Peck
[1.1.1.3.7.2.8.1.6.2]
b. 8 Feb 1903 d. 21 Jul 1992
Alfred Walter Stevenson
b. 6 Oct 1900 d. 27 Nov 1974
11
Mitzi Stevenson
[1.1.1.3.7.2.8.1.6.2.1]
b. 14 Mar 1926 d. 12 Aug 2014
11
Patricia Stevenson
[1.1.1.3.7.2.8.1.6.2.2]
b. 4 Apr 1929 d. 17 Feb 2008
11
Walter Peck Stevenson
[1.1.1.3.7.2.8.1.6.2.3]
b. 17 Feb 1939 d. 21 Apr 2001
10
Leo Benson Peck
[1.1.1.3.7.2.8.1.6.3]
b. 20 Jul 1905 d. 18 Nov 1917
10
Maurine Peck
[1.1.1.3.7.2.8.1.6.4]
b. 22 Nov 1907 d. 4 Aug 1935
Kennett Highly Malan
b. 16 Apr 1904 d. 13 Apr 1977
11
Maurine Malan
[1.1.1.3.7.2.8.1.6.4.1]
b. 13 May 1930 d. 13 May 1930
11
Kennett Darrett " Dart " Peck Malan
[1.1.1.3.7.2.8.1.6.4.2]
b. 21 Aug 1931 d. 5 Apr 2010
11
Son Malan
[1.1.1.3.7.2.8.1.6.4.3]
b. 2 Aug 1935 d. 2 Aug 1935
10
Beth Peck
[1.1.1.3.7.2.8.1.6.5]
b. 24 Sep 1912 d. 8 Sep 2000
+
Ernest Hugh Ford
b. 1 Apr 1912 d. 27 Jan 2006
10
Garth Benson Peck
[1.1.1.3.7.2.8.1.6.6]
b. 18 Apr 1916 d. 14 Dec 1993
+
Living
10
Olive Louise Peck
[1.1.1.3.7.2.8.1.6.7]
b. 22 Jun 1920 d. 24 Aug 1993
Joseph Curran Foley
b. 19 Dec 1911 d. 9 Aug 2003
11
Living
[1.1.1.3.7.2.8.1.6.7.1]
11
Living
[1.1.1.3.7.2.8.1.6.7.2]
9
Florence Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.7]
b. 31 Jul 1879 d. 5 Nov 1967
Stanley Detlef Jonasson
b. 4 Mar 1878 d. 8 May 1959
10
Adeline Jonasson
[1.1.1.3.7.2.8.1.7.1]
b. 5 Nov 1906 d. 23 Jul 1975
+
Julius Louis Helvey
b. 14 Sep 1901 d. 15 Oct 1968
10
Stanley Taft Jonasson
[1.1.1.3.7.2.8.1.7.2]
b. 29 Aug 1908 d. 9 Dec 1986
+
Claire Anna Schneider
b. 22 Jun 1907 d. 22 Feb 1981
10
Helen Jonasson
[1.1.1.3.7.2.8.1.7.3]
b. 27 Sep 1910 d. 17 Oct 1931
10
Dorothy Jonasson
[1.1.1.3.7.2.8.1.7.4]
b. 1912 d. 1912
10
Alfred Benson ( Bill ) Jonasson
[1.1.1.3.7.2.8.1.7.5]
b. 26 Feb 1919 d. 16 Dec 2000
9
William Kennedy Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.8]
b. 9 Feb 1882 d. 28 Feb 1882
9
Frank Taft Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.9]
b. 23 Apr 1883 d. 19 Feb 1923
Elizabeth Greaves "Lillie" Eames
b. 6 Jun 1884 d. 28 Dec 1966
10
Gladys Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.9.1]
b. 12 Nov 1909 d. 27 Jan 1995
Don Giles Nelson
b. 8 Sep 1904 d. 25 Jan 1985
11
Kaye Fred Nelson
[1.1.1.3.7.2.8.1.9.1.1]
b. 10 Mar 1932 d. 11 Jun 2009
Living
12
Living
[1.1.1.3.7.2.8.1.9.1.1.1]
[
=>
]
12
Eric Nelson
[1.1.1.3.7.2.8.1.9.1.1.2]
12
Kirsten Nelson
[1.1.1.3.7.2.8.1.9.1.1.3]
12
Marta Nelson
[1.1.1.3.7.2.8.1.9.1.1.4]
11
Frankie Nelson
[1.1.1.3.7.2.8.1.9.1.2]
b. 1 Jan 1937 d. 22 Nov 2021
Alvin Eugene "Gene" Whipple
b. 7 Mar 1935 d. 7 Jul 2020
12
Living
[1.1.1.3.7.2.8.1.9.1.2.1]
[
=>
]
12
Living
[1.1.1.3.7.2.8.1.9.1.2.2]
[
=>
]
12
Living
[1.1.1.3.7.2.8.1.9.1.2.3]
[
=>
]
12
Living
[1.1.1.3.7.2.8.1.9.1.2.4]
[
=>
]
12
Living
[1.1.1.3.7.2.8.1.9.1.2.5]
[
=>
]
12
Living
[1.1.1.3.7.2.8.1.9.1.2.6]
[
=>
]
11
Lorraine Nelson
[1.1.1.3.7.2.8.1.9.1.3]
b. 30 Dec 1943 d. 30 Jan 2016
John Berry Brown, Jr
b. 6 Apr 1940 d. 3 Feb 2022
12
Living
[1.1.1.3.7.2.8.1.9.1.3.1]
12
Laurie Brown
[1.1.1.3.7.2.8.1.9.1.3.2]
b. 19 Aug [
=>
]
12
Living
[1.1.1.3.7.2.8.1.9.1.3.3]
[
=>
]
12
Alisha Brown
[1.1.1.3.7.2.8.1.9.1.3.4]
b. 4 Apr 1973 d. 10 Apr 2005 [
=>
]
10
Carmen Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.9.2]
b. 4 Nov 1911 d. 17 Aug 2001
Robert Moss Lewis, Jr
b. 16 Mar 1909 d. 6 Jul 1985
11
Ann Lewis
[1.1.1.3.7.2.8.1.9.2.1]
b. 20 Dec 1937 d. 7 Aug 2016
+
Carvel B Stephenson, Jr
b. 24 Mar 1934 d. 24 Feb 1993
11
Colleen Lewis
[1.1.1.3.7.2.8.1.9.2.2]
+
Warren Wilde
11
Robert Moss Lewis, III
[1.1.1.3.7.2.8.1.9.2.3]
+
Renae
11
Harold Benson Lewis
[1.1.1.3.7.2.8.1.9.2.4]
+
Julie
11
Carmen Lynne Lewis
[1.1.1.3.7.2.8.1.9.2.5]
+
Steve Cherreinton
11
Elizabeth Lewis
[1.1.1.3.7.2.8.1.9.2.6]
+
Bud Alford
10
Harold Eames Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.9.3]
b. 4 Nov 1911 d. 20 Jul 1948
Shirley Anderson
b. 17 Aug 1929 d. 8 Aug 2015
11
Linda Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.9.3.1]
b. 10 Mar 1948 d. 14 Sep 2000
Earl Flinders Gilbert
b. 13 Aug 1939 d. 25 Dec 2007
12
Michelle Gilbert
[1.1.1.3.7.2.8.1.9.3.1.1]
b. 8 May 1972 d. 18 May 1972
10
Flora Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.9.4]
b. 30 Jan 1916 d. 14 Oct 1984
Lorin George Ransom
b. 8 Mar 1913 d. 14 Mar 1998
11
Lorin Gene Ransom
[1.1.1.3.7.2.8.1.9.4.1]
11
Clair Benson Ransom
[1.1.1.3.7.2.8.1.9.4.2]
11
Lee Ann Ransom
[1.1.1.3.7.2.8.1.9.4.3]
11
George Benson Ransom
[1.1.1.3.7.2.8.1.9.4.4]
10
Zenda Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.9.5]
b. 25 Oct 1918 d. 27 Feb 2003
Kember Dee Mabey
b. 24 May 1917 d. 21 Sep 1987
11
Paula Mabey
[1.1.1.3.7.2.8.1.9.5.1]
+
Cummings
11
T Dee Mabey
[1.1.1.3.7.2.8.1.9.5.2]
+
Danna
11
Lynn Mabey
[1.1.1.3.7.2.8.1.9.5.3]
+
Janice
11
Mark Mabey
[1.1.1.3.7.2.8.1.9.5.4]
+
Caroline
10
Frank Eames Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.9.6]
b. 26 Sep 1920 d. 2 Jan 1923
10
Nellie Louisa Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.9.7]
b. 11 Sep 1923 d. 11 Oct 1975
Louis Victor Christensen
b. 1 Oct 1922 d. 18 Mar 2011
11
Kathleen Christensen
[1.1.1.3.7.2.8.1.9.7.1]
b. 16 Jan 1944 d. 16 Apr 2022
+
Roland Dean Benedict
b. 28 Apr 1926 d. 16 Dec 1989
11
Dale Benson Christensen
[1.1.1.3.7.2.8.1.9.7.2]
11
Michael Benson Christensen
[1.1.1.3.7.2.8.1.9.7.3]
11
Frank Benson Christensen
[1.1.1.3.7.2.8.1.9.7.4]
b. 19 Jun 1950 d. 2 Sep 1992
11
Kelly Benson Christensen
[1.1.1.3.7.2.8.1.9.7.5]
b. 4 Jun 1954 d. 24 Jun 2006
Living
12
Living
[1.1.1.3.7.2.8.1.9.7.5.1]
12
Living
[1.1.1.3.7.2.8.1.9.7.5.2]
11
Ludean Benson Christensen
[1.1.1.3.7.2.8.1.9.7.6]
11
David Benson Christensen
[1.1.1.3.7.2.8.1.9.7.7]
11
Louis Benson Christensen
[1.1.1.3.7.2.8.1.9.7.8]
b. 16 May 1960 d. 30 Apr 2020
9
Marie Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.10]
b. 19 Jul 1885 d. 6 Mar 1891
9
Carmen Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.11]
b. 7 Nov 1887 d. 5 Jul 1974
Franklin Brenneman Smith, Jr
b. Abt 1860 d. 11 Apr 1954
10
Franklin Breneman Smith, III
[1.1.1.3.7.2.8.1.11.1]
b. 11 Jun 1923 d. 3 Apr 2009
10
Richard Benson Smith
[1.1.1.3.7.2.8.1.11.2]
b. 15 Jun 1925 d. 8 Dec 2009
9
Jenny Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.12]
b. 30 Jun 1890 d. 12 Jul 1970
Earl Weaver
b. 22 Jun 1890 d. 11 Oct 1977
10
Kinnie Weaver
[1.1.1.3.7.2.8.1.12.1]
b. 30 May 1916 d. 27 Aug 1999
+
Joseph Frederick Johnsen
b. 24 Apr 1913 d. 18 Jan 1999
10
Virginia Weaver
[1.1.1.3.7.2.8.1.12.2]
b. 23 Dec 1917 d. 2012
+
Earl Midsland Kooyman
b. 24 Aug 1917 d. 8 Sep 1996
James Ross Reed, Jr
b. 10 Jan 1915 d. 3 Jan 1986
11
Peggy Jane Reed
[1.1.1.3.7.2.8.1.12.2.1]
b. 22 Jun 1953 d. 21 Dec 2016
10
Mary Louise "Louie" Weaver
[1.1.1.3.7.2.8.1.12.3]
b. 15 Jun 1921 d. 16 May 2012
Lynn John Lawrence
b. 25 Nov 1916 d. 25 Jul 2003
11
Mark Dugan Lawrence
[1.1.1.3.7.2.8.1.12.3.1]
b. 1946 d. 2009
11
Steve Weaver Lawrence
[1.1.1.3.7.2.8.1.12.3.2]
b. 1949 d. 2007
11
Rick Lawrence
[1.1.1.3.7.2.8.1.12.3.3]
11
Kinnie Lawrence
[1.1.1.3.7.2.8.1.12.3.4]
11
Brad Lawrence
[1.1.1.3.7.2.8.1.12.3.5]
10
Earl Benson Weaver
[1.1.1.3.7.2.8.1.12.4]
b. 27 Oct 1926 d. 1 Jan 2015
Barnara Ellen Smith
11
Melody Weaver
[1.1.1.3.7.2.8.1.12.4.1]
Patrick Gallegos
12
Kelsey Gallegos
[1.1.1.3.7.2.8.1.12.4.1.1]
12
Derek Gallegos
[1.1.1.3.7.2.8.1.12.4.1.2]
10
Jenalee Weaver
[1.1.1.3.7.2.8.1.12.5]
b. 1929 d. Aug 2015
9
Kathinka "Kinnie" Benson
[1.1.1.3.7.2.8.1.13]
b. 15 Mar 1894 d. 20 May 1960
Robert Sweeten Holbrook
b. 14 Oct 1893 d. 2 Jun 1980
10
Robert Benson Holbrook
[1.1.1.3.7.2.8.1.13.1]
b. 5 Aug 1917 d. 29 Feb 2000
Marjorie Ruth Kroescher
b. 24 Mar 1918 d. 12 Aug 2004
11
Brent Kroescher Holbrook
[1.1.1.3.7.2.8.1.13.1.1]
b. 11 May 1956 d. 7 Dec 1974
10
George Benson Holbrook
[1.1.1.3.7.2.8.1.13.2]
b. 3 Nov 1919 d. 7 Nov 2009
Norma Mowrey
b. 16 Aug 1921 d. 5 Nov 1999
11
Carol Ann Holbrook
[1.1.1.3.7.2.8.1.13.2.1]
b. 3 Jul 1949 d. 25 Nov 2009
11
Dorothy Holbrook
[1.1.1.3.7.2.8.1.13.2.2]
b. 26 Jun 1945 d. 26 Jun 1945
11
Bryan David Holbrook
[1.1.1.3.7.2.8.1.13.2.3]
b. 5 Mar 1943 d. 5 Mar 1943
11
Kathleen Holbrook
[1.1.1.3.7.2.8.1.13.2.4]
b. 6 Jan 1942 d. 6 Jan 1942
11
Daughter Holbrook
[1.1.1.3.7.2.8.1.13.2.5]
b. 1944 d. 1944
10
Louise Holbrook
[1.1.1.3.7.2.8.1.13.3]
b. 4 Jun 1912 d. 27 May 2009
Paul Jennings Callahan
b. 21 Jan 1912 d. 22 Jul 1982
11
Living
[1.1.1.3.7.2.8.1.13.3.1]
11
Phillip Paul Callahan
[1.1.1.3.7.2.8.1.13.3.2]
b. 10 Nov 1963 d. 19 Feb 2001
10
Donald Benson Holbrook
[1.1.1.3.7.2.8.1.13.4]
b. 4 Feb 1925 d. 1 Mar 2005
11
Mark Donald Holbrook
[1.1.1.3.7.2.8.1.13.4.1]
b. 11 Dec 1953 d. 27 Oct 1991
11
James Gregory Holbrook
[1.1.1.3.7.2.8.1.13.4.2]
b. 19 Dec 1957 d. 26 May 1993
10
Gordon Benson Holbrook
[1.1.1.3.7.2.8.1.13.5]
b. 22 Dec 1926 d. 2 Nov 1993
Claire Colleen Wamsley
b. 11 Apr 1926 d. 13 Oct 1978
11
Gordon Lee Holbrook
[1.1.1.3.7.2.8.1.13.5.1]
b. 16 Aug 1950 d. 26 Aug 2000
12
Nathaniel Shane Holbrook
[1.1.1.3.7.2.8.1.13.5.1.1]
b. 26 Jan 1979 d. 18 Oct 2009
11
Susan Holbrook
[1.1.1.3.7.2.8.1.13.5.2]
b. 12 May 1948 d. 19 Jul 2002
+
Norma Louise Leston Strike
b. 29 Dec 1925 d. 25 Jul 1998
8
Marie Jeanne Ballif
[1.1.1.3.7.2.8.2]
b. 6 Jan 1852 d. 29 May 1926
Aaron Dunham Thatcher
b. 25 Apr 1837 d. 8 Sep 1909
9
Elise Thatcher
[1.1.1.3.7.2.8.2.1]
b. 17 Nov 1872 d. 21 Oct 1881
9
Marie Ollie Thatcher
[1.1.1.3.7.2.8.2.2]
b. 2 Aug 1875 d. 12 Apr 1973
Charles Wilson Nibley, Jr
b. 7 Apr 1872 d. 19 Oct 1959
10
Ollie Jean Nibley
[1.1.1.3.7.2.8.2.2.1]
b. 16 Jul 1899 d. 16 Jan 1919
+
Wesley Grant Howell
b. 24 Nov 1898 d. 5 Dec 1963
10
Charles Wilson Nibley, III
[1.1.1.3.7.2.8.2.2.2]
b. 19 Jan 1901 d. 11 Sep 1978
10
Aaron Thatcher Nibley
[1.1.1.3.7.2.8.2.2.3]
b. 1 Nov 1903 d. 21 Jul 1985
Cleora Barnicoat Torrey
b. 2 Jul 1906 d. 17 Mar 1994
11
Priscilla Gertrude Nibley
[1.1.1.3.7.2.8.2.2.3.1]
b. 11 Feb 1937 d. 9 Nov 2006
10
Eva Nibley
[1.1.1.3.7.2.8.2.2.4]
b. 1904
10
Bonna Nibley
[1.1.1.3.7.2.8.2.2.5]
b. 12 Mar 1905 d. 25 Sep 1963
Robert Lashbrook Gordon
b. 19 Mar 1904 d. 13 Apr 1978
11
Robert Lashbrook Gordon, Jr
[1.1.1.3.7.2.8.2.2.5.1]
b. 8 Jul 1930 d. 3 Sep 2006
11
Charles Nibley Gordon
[1.1.1.3.7.2.8.2.2.5.2]
b. 9 Aug 1934 d. 12 Jan 1997
10
Alonzo George Nibley
[1.1.1.3.7.2.8.2.2.6]
b. 17 Oct 1906 d. 26 Nov 1992
+
Lillian Frances Novacek
b. 7 Jul 1919 d. 16 Mar 2003
10
Jeff Thatcher Nibley
[1.1.1.3.7.2.8.2.2.7]
b. 4 Oct 1912 d. 23 Sep 2001
10
Joseph Edgar Nibley
[1.1.1.3.7.2.8.2.2.8]
b. 16 Jan 1915 d. 16 Jan 1915
9
Aaron Dunham Thatcher, Jr
[1.1.1.3.7.2.8.2.3]
b. 3 Oct 1877 d. 8 Dec 1959
Effie Jane Skelton
b. 18 Aug 1883 d. 19 Sep 1972
10
Aaron D Thatcher
[1.1.1.3.7.2.8.2.3.1]
b. 1 Jan 1910 d. 19 Dec 1915
10
Mabel Louise Thatcher
[1.1.1.3.7.2.8.2.3.2]
b. 4 Aug 1915 d. 20 Jul 1996
+
Robert Burton Pritchett
b. 7 Jul 1917 d. 30 Jan 1995
10
Sidney Kent Thatcher
[1.1.1.3.7.2.8.2.3.3]
b. 2 Dec 1917 d. 24 Nov 2003
10
Ralph Skelton Thatcher
[1.1.1.3.7.2.8.2.3.4]
b. 20 Mar 1928 d. 26 Apr 2009
9
Afton Thatcher
[1.1.1.3.7.2.8.2.4]
b. 30 Apr 1880 d. 19 Aug 1954
Franklin Charles Bramwell
b. 21 Dec 1881 d. 12 Feb 1943
10
Franklin Charles Bramwell
[1.1.1.3.7.2.8.2.4.1]
b. 7 May 1914 d. 6 Aug 1959
10
Edgar Thatcher Bramwell
[1.1.1.3.7.2.8.2.4.2]
b. 20 Jun 1916 d. 7 Jan 2002
+
Jean Ann Miller
b. 31 Mar 1918 d. 1 Jun 1998
10
Aaron Thatcher Bramwell
[1.1.1.3.7.2.8.2.4.3]
b. 10 Jul 1918 d. 7 Mar 1923
9
Genevieve Thatcher
[1.1.1.3.7.2.8.2.5]
b. 19 Aug 1883 d. 21 May 1973
9
Edgar Ballif Thatcher
[1.1.1.3.7.2.8.2.6]
b. 5 Dec 1884 d. 18 May 1963
+
Myrtle Cordilia Hyde
b. 1 Apr 1889 d. 2 Jul 1975
9
Louise Ballif Thatcher
[1.1.1.3.7.2.8.2.7]
b. 10 Jan 1888 d. 1 Nov 1979
Franklin Horrocks Rolapp
b. 9 Oct 1888 d. 31 Jul 1975
10
Henry Thatcher Rolapp
[1.1.1.3.7.2.8.2.7.1]
b. 10 Sep 1912 d. 5 Feb 1997
Jane L Whitmore
b. 12 Nov 1914 d. 15 Oct 1967
11
Fredrick Henry Rolapp
[1.1.1.3.7.2.8.2.7.1.1]
b. 12 May 1942 d. 8 Nov 2009
10
Ralph Thatcher Rolapp
[1.1.1.3.7.2.8.2.7.2]
b. 3 Mar 1916 d. 4 Apr 1994
Barbara Howell Richards
b. 28 Apr 1918 d. 27 Nov 1988
11
Ralph Richards Rolapp
[1.1.1.3.7.2.8.2.7.2.1]
b. 31 Dec 1940 d. 14 May 1993
11
Donald Rolapp
[1.1.1.3.7.2.8.2.7.2.2]
b. 29 Sep 1945 d. 30 Apr 2005
10
Franklin Thatcher Rolapp
[1.1.1.3.7.2.8.2.7.3]
b. 17 Mar 1918 d. 15 Apr 1965
Elizabeth Marie Graul
b. 14 Jan 1917 d. 31 Mar 2007
11
Donald Rolapp
[1.1.1.3.7.2.8.2.7.3.1]
b. 29 Sep 1945 d. 30 Apr 2005
10
Edgar Thatcher Rolapp
[1.1.1.3.7.2.8.2.7.4]
b. 30 Sep 1921 d. 14 Dec 2008
9
Harriett Ballif Thatcher
[1.1.1.3.7.2.8.2.8]
b. 26 Aug 1891 d. 28 Oct 1915
8
Helen Ballif
[1.1.1.3.7.2.8.3]
b. 8 Apr 1853 d. May 1854
8
Kathinka Caroline Ballif
[1.1.1.3.7.2.8.4]
b. 23 Sep 1855 d. 25 Nov 1937
John Thomas Caine, Jr
b. 9 Mar 1854 d. 8 Aug 1940
9
Margaret Nightingale Caine
[1.1.1.3.7.2.8.4.1]
b. 11 Oct 1879 d. 7 Feb 1883
9
John Thomas Caine, III
[1.1.1.3.7.2.8.4.2]
b. 4 Jun 1882 d. 5 Jul 1955
Jean Crookston
b. 27 Nov 1887 d. 26 May 1972
10
Margaret Jean Caine
[1.1.1.3.7.2.8.4.2.1]
b. 15 Sep 1913 d. Apr 1988
+
Andrew Daniel Shalley
b. 18 Jun 1911 d. Nov 1981
10
John Thomas Caine, IV
[1.1.1.3.7.2.8.4.2.2]
b. 18 Sep 1916 d. 21 Nov 1994
11
John Thomas Caine, V
[1.1.1.3.7.2.8.4.2.2.1]
b. 17 May 1948 d. 12 Nov 2007
10
Robert Preston Caine
[1.1.1.3.7.2.8.4.2.3]
b. 30 Jun 1920 d. 10 Feb 1994
+
Kathryn Anderson
b. 3 Mar 1922 d. 13 Mar 2000
10
William Serge Caine
[1.1.1.3.7.2.8.4.2.4]
b. 21 Nov 1925 d. 11 Mar 1927
9
Blanche Elise Caine
[1.1.1.3.7.2.8.4.3]
b. 15 Dec 1883 d. 1 Mar 1971
George Lyman Hyde
b. 24 Jun 1885 d. 14 Jul 1967
10
Virginia Caine Hyde
[1.1.1.3.7.2.8.4.3.1]
b. 5 May 1913
9
Lawrence Baliff Caine
[1.1.1.3.7.2.8.4.4]
b. 22 May 1886 d. 10 Dec 1963
Venus Elizabeth Frazee
b. 6 Jun 1888 d. 28 Nov 1941
10
Lawrence B Caine
[1.1.1.3.7.2.8.4.4.1]
b. 24 Jan 1914 d. 4 Jun 1994
Marcella M McHugh
b. 13 Aug 1916 d. 4 Oct 2000
11
Lawrence B Caine
[1.1.1.3.7.2.8.4.4.1.1]
b. 5 Sep 1944 d. 7 Sep 1982
10
Ruth Elizabeth Caine
[1.1.1.3.7.2.8.4.4.2]
b. 2 Nov 1915 d. Mar 1973
+
Wendell Twitchell
b. 14 Jul 1913 d. 8 Mar 2002
10
Marion Caine
[1.1.1.3.7.2.8.4.4.3]
b. Abt 1917 d. 2000
10
Marjorie Caine
[1.1.1.3.7.2.8.4.4.4]
b. 6 Mar 1920 d. 7 Jan 2007
+
Junius Wells Robins
b. 15 Oct 1919 d. 21 Feb 2012
+
Ann Little
b. 27 May 1897 d. 11 Apr 1999
9
Joseph Lester Caine
[1.1.1.3.7.2.8.4.5]
b. 20 Dec 1887 d. 18 Jan 1888
9
George Balliff Caine
[1.1.1.3.7.2.8.4.6]
b. 16 Sep 1889 d. 4 Jun 1969
Marie Stoddard Eccles
b. 2 Nov 1892 d. 14 Sep 1981
10
Kathryn Marie Caine
[1.1.1.3.7.2.8.4.6.1]
b. 2 Nov 1916 d. 30 Sep 2011
10
George Eccles Caine
[1.1.1.3.7.2.8.4.6.2]
b. 28 Jul 1921 d. 11 Apr 2012
9
Alfred Ballif Caine
[1.1.1.3.7.2.8.4.7]
b. 13 Sep 1891 d. 18 Aug 1950
Anna Kirstina Taylor
b. 9 Jul 1895 d. 29 Dec 1952
10
Richard Taylor Caine
[1.1.1.3.7.2.8.4.7.1]
b. 22 May 1919 d. 24 Mar 1980
10
Barbara Ann Caine
[1.1.1.3.7.2.8.4.7.2]
b. 22 Jan 1923 d. 16 Mar 2017
10
Living
[1.1.1.3.7.2.8.4.7.3]
9
Arthur Hugh Caine
[1.1.1.3.7.2.8.4.8]
b. 11 Aug 1893 d. 22 Feb 1986
Gladys Wright Smith
b. 3 Nov 1895 d. 13 Nov 1990
10
Helen Nightingale Caine
[1.1.1.3.7.2.8.4.8.1]
b. 18 Mar 1921 d. 18 Jul 2011
+
Scott Morey Schlofman
b. 21 Nov 1921 d. 28 Jun 1992
10
Barbara Marie Caine
[1.1.1.3.7.2.8.4.8.2]
b. 9 Oct 1922 d. 16 Aug 1996
+
John Major Scowcroft
b. 19 Jun 1924 d. 11 Dec 1999
10
Arthur Dixon Caine
[1.1.1.3.7.2.8.4.8.3]
b. 16 Sep 1925 d. 8 Jan 2012
9
Kinnie Clair Caine
[1.1.1.3.7.2.8.4.9]
b. 6 Mar 1898 d. 31 Mar 1928
8
Rachel Elizabeth Ballif
[1.1.1.3.7.2.8.5]
b. 2 Jan 1857 d. 27 Jan 1941
Robert Stewart Campbell
b. 6 Nov 1854 d. 5 Sep 1931
9
Robert Lionel Campbell
[1.1.1.3.7.2.8.5.1]
b. 2 Jul 1878 d. 29 May 1931
Laura Josephine Sanders
b. 28 Jun 1878 d. 23 Aug 1971
10
Robert Sanders Campbell
[1.1.1.3.7.2.8.5.1.1]
b. 25 Sep 1904 d. Dec 1969
Edythe Ann Perrault
b. 18 Jun 1907 d. Nov 1972
11
Susan Campbell
[1.1.1.3.7.2.8.5.1.1.1]
b. 16 Jun 1937 d. 10 Nov 2000
10
Lionel Thaddeus Campbell
[1.1.1.3.7.2.8.5.1.2]
b. 28 Jun 1910 d. 3 Sep 1984
+
Bertha Moore
b. 23 May 1910 d. Mar 1963
10
William Sanders Campbell
[1.1.1.3.7.2.8.5.1.3]
b. 10 Mar 1922 d. 13 Jul 2001
9
Serge Ballif Campbell
[1.1.1.3.7.2.8.5.2]
b. 5 Oct 1880 d. 5 Feb 1965
Ruby Erskine
b. 10 Nov 1886 d. 22 Oct 1957
10
Blaine Ballif Campbell
[1.1.1.3.7.2.8.5.2.1]
b. 27 May 1913 d. 10 Aug 1987
+
Marian Dilworth Wilson
b. 13 Feb 1918 d. 6 Sep 2009
10
Paul Erskine Campbell
[1.1.1.3.7.2.8.5.2.2]
b. 3 Jun 1915 d. 16 Jan 1976
+
Helen Mason
b. 1 Aug 1917 d. 11 Oct 2006
10
Serge Lang Campbell
[1.1.1.3.7.2.8.5.2.3]
b. 31 Mar 1918 d. 1 Feb 1989
Mildred Brown
b. 28 Jun 1916 d. 6 Apr 2007
11
Pamela Campbell
[1.1.1.3.7.2.8.5.2.3.1]
b. 14 Jul 1940 d. 9 May 2013
10
Douglas Clive Campbell
[1.1.1.3.7.2.8.5.2.4]
b. 28 Mar 1920 d. 24 Apr 2003
10
Beverly Campbell
[1.1.1.3.7.2.8.5.2.5]
b. 18 Feb 1924 d. 2014
9
Rachel Elise Campbell
[1.1.1.3.7.2.8.5.3]
b. 25 Jan 1883 d. 9 Sep 1969
+
Clayton Van Kuren Smith
b. 16 Mar 1886 d. 5 Jun 1962
9
Donald Stewart Campbell
[1.1.1.3.7.2.8.5.4]
b. 27 May 1885 d. 15 Mar 1946
Viola Blanche Denhalter
b. 8 Sep 1887 d. 16 Aug 1954
10
Mignon Campbell
[1.1.1.3.7.2.8.5.4.1]
b. 22 Jun 1914 d. Mar 1974
10
Adelaide Jean Campbell
[1.1.1.3.7.2.8.5.4.2]
b. 17 May 1917 d. 4 Aug 1973
9
Jeanne D'Arc Campbell
[1.1.1.3.7.2.8.5.5]
b. 13 Oct 1888 d. 12 Nov 1905
9
Loys Clive Campbell
[1.1.1.3.7.2.8.5.6]
b. 20 Sep 1891 d. 1 Jan 1912
9
Florence Campbell
[1.1.1.3.7.2.8.5.7]
b. 13 Jan 1894 d. 20 Jan 1983
Gilbert Winder Williams
b. 20 Jan 1892 d. 18 Jul 1975
10
Adele Williams
[1.1.1.3.7.2.8.5.7.1]
b. 19 Sep 1915 d. 7 Jan 2014
10
Richard Campbell Williams
[1.1.1.3.7.2.8.5.7.2]
b. 19 Oct 1917 d. 28 Jan 2000
+
Marian Grant Judd
b. 11 Dec 1918 d. 4 Sep 2010
10
Douglas Campbell Williams
[1.1.1.3.7.2.8.5.7.3]
b. 13 Jan 1923 d. Feb 1999
9
Helen Campbell
[1.1.1.3.7.2.8.5.8]
b. 17 Jan 1898 d. 8 May 1899
8
Sergine Cecile Ballif
[1.1.1.3.7.2.8.6]
b. 19 Apr 1858 d. Nov 1859
8
Serge Frederick Ballif
[1.1.1.3.7.2.8.7]
b. 21 Sep 1859 d. 17 Nov 1942
Zelnora Eliza Angell
b. 26 Jul 1858 d. 11 Apr 1924
9
Hazel Ballif
[1.1.1.3.7.2.8.7.1]
b. 5 Nov 1886 d. 5 Mar 1921
Charles William Rees
b. 21 Mar 1886 d. 7 May 1972
10
Charles William Rees
[1.1.1.3.7.2.8.7.1.1]
b. 25 May 1914 d. 30 Mar 1919
10
Rachel Louise Rees
[1.1.1.3.7.2.8.7.1.2]
b. 12 Nov 1916 d. 21 Mar 1917
10
Marjorie Rees
[1.1.1.3.7.2.8.7.1.3]
b. 31 May 1918 d. 10 Jul 1919
9
Serge Frederick Ballif, Jr
[1.1.1.3.7.2.8.7.2]
b. 27 Oct 1888 d. 22 Jul 1958
Martha May Belle Rolapp
b. 18 May 1892 d. 22 Mar 1983
10
Martha Ruth Ballif
[1.1.1.3.7.2.8.7.2.1]
b. 24 Mar 1914 d. 12 Mar 1961
Charles Reed Smoot
b. 16 May 1915 d. 19 Jun 1996
11
Peter Charles Smoot
[1.1.1.3.7.2.8.7.2.1.1]
b. 10 Jul 1945 d. 6 May 2013
10
Marian May Belle Ballif
[1.1.1.3.7.2.8.7.2.2]
b. 30 Apr 1916 d. 10 Dec 1978
10
Zelnora Jean Ballif
[1.1.1.3.7.2.8.7.2.3]
b. 11 Feb 1918 d. 7 Dec 1976
10
Serge Rolapp Ballif
[1.1.1.3.7.2.8.7.2.4]
b. 3 Aug 1920 d. 14 Jun 1998
+
Vera Zelma Myers
b. 22 Oct 1921 d. 12 Feb 2004
10
Dorothy Louise Ballif
[1.1.1.3.7.2.8.7.2.5]
b. 22 Dec 1922 d. 13 Aug 1993
+
John Byrd Wilson
b. 9 Nov 1913 d. 6 Apr 1994
9
Leonard Humbert Ballif
[1.1.1.3.7.2.8.7.3]
b. 12 Jan 1894 d. 21 Mar 1954
Jeanette Ure Grow
b. 15 Aug 1898 d. Sep 1976
10
Leonard Humbert Ballif, Jr
[1.1.1.3.7.2.8.7.3.1]
b. 26 Jun 1920 d. 9 Apr 1942
10
Rae Ballif
[1.1.1.3.7.2.8.7.3.2]
b. 20 Aug 1928 d. 19 Dec 2005
10
Living
[1.1.1.3.7.2.8.7.3.3]
10
Catherine Lou Ballif
[1.1.1.3.7.2.8.7.3.4]
b. 16 Mar 1936 d. 8 Sep 2020
9
Zelnora Ballif
[1.1.1.3.7.2.8.7.4]
b. 9 Aug 1896 d. 26 Jun 1976
William Henry Evans
b. 4 Feb 1893 d. 20 Dec 1981
10
Ballif Howard Evans
[1.1.1.3.7.2.8.7.4.1]
b. 20 Oct 1919 d. 21 Aug 1991
+
Elizabeth Jane Tickner
b. 13 Apr 1921 d. 9 Nov 1993
10
Janeth Ann Evans
[1.1.1.3.7.2.8.7.4.2]
b. 23 Jul 1925 d. 18 Feb 1993
+
Glen Alvin Doxey
b. 14 Aug 1923 d. 29 Dec 2001
9
Rachel Ballif
[1.1.1.3.7.2.8.7.5]
b. 5 Mar 1899 d. 3 Dec 1926
Wendell Brown Lyman
b. 18 Dec 1897 d. 13 May 1933
10
Amy Kathryn Lyman
[1.1.1.3.7.2.8.7.5.1]
b. 22 Apr 1925 d. 31 Oct 1996
9
Evelyn Ballif
[1.1.1.3.7.2.8.7.6]
b. 2 Apr 1901 d. 16 Jan 1995
Wilford Owen Woodruff
b. 31 Oct 1899 d. 30 Jun 1986
10
Truman Owen Woodruff
[1.1.1.3.7.2.8.7.6.1]
b. 26 May 1925 d. 13 Apr 2007
+
Ambrosina Francesca Solaroli
b. 4 Oct 1925 d. 14 Jun 1991
+
Patricia O'Keefe Vincent
10
Jacquelyn Woodruff
[1.1.1.3.7.2.8.7.6.2]
b. 20 Jan 1927 d. 15 Jun 2020
Blaine Snow Clements
b. 9 Aug 1925 d. 21 May 2017
11
Michael Clements
[1.1.1.3.7.2.8.7.6.2.1]
+
Rogene
11
Sharie Clements
[1.1.1.3.7.2.8.7.6.2.2]
+
Michael Johnson
11
Jordan Clements
[1.1.1.3.7.2.8.7.6.2.3]
+
Julie
11
Joni Clements
[1.1.1.3.7.2.8.7.6.2.4]
+
Clay Henderson
10
Serge Ballif Woodruff
[1.1.1.3.7.2.8.7.6.3]
b. 20 Mar 1929 d. 12 May 2020
Marilyn Martin
b. 27 Nov 1930 d. 6 Jun 1998
11
Wendy Woodruff
[1.1.1.3.7.2.8.7.6.3.1]
b. 26 Jan 1954 d. 8 Jan 2014
+
Blaine Kellogg
11
Samuel M Woodruff
[1.1.1.3.7.2.8.7.6.3.2]
+
Cherri
11
Amy Woodruff
[1.1.1.3.7.2.8.7.6.3.3]
+
Richard Bernard
11
Matthew M Woodruff
[1.1.1.3.7.2.8.7.6.3.4]
+
Lisa
11
David M Woodruff
[1.1.1.3.7.2.8.7.6.3.5]
+
Lynnae
10
Nathan Howard Woodruff
[1.1.1.3.7.2.8.7.6.4]
b. 11 May 1931 d. 17 Jun 1986
+
Glenna Carlsen
b. 25 Jun 1930 d. 18 Jun 2017
8
John Lyman Ballif
[1.1.1.3.7.2.8.8]
b. 23 Dec 1863 d. 6 Dec 1941
Emma Gurney Smith
b. 19 Oct 1864 d. 3 Apr 1942
9
John Lyman Ballif, Jr
[1.1.1.3.7.2.8.8.1]
b. 9 Aug 1887 d. 15 Mar 1954
Cora Hansen
b. 12 Apr 1886 d. 22 Jun 1964
10
Marsha Ballif
[1.1.1.3.7.2.8.8.1.1]
b. 19 Jun 1919 d. 23 Oct 2004
+
Grant Winder Midgley
b. 2 Aug 1911 d. 9 Dec 2003
10
John Lyman Ballif, III
[1.1.1.3.7.2.8.8.1.2]
b. 17 May 1926 d. 20 May 2006
+
Barbara Nielson
b. 12 Jul 1930 d. 2 Feb 2005
9
Emma Claremond Balliff
[1.1.1.3.7.2.8.8.2]
b. 27 Dec 1891 d. 12 May 1961
Ernest Garfield Woodvine
b. 24 Aug 1881 d. 1946
10
Reginald Ballif Woodvine
[1.1.1.3.7.2.8.8.2.1]
b. 22 Apr 1908 d. 19 Dec 1984
10
Max Ballif Woodvine
[1.1.1.3.7.2.8.8.2.2]
b. 7 Jun 1910 d. 31 Dec 1998
Roy Poole Yearsley
b. 21 May 1884 d. 5 Sep 1961
10
Son Yearsley
[1.1.1.3.7.2.8.8.2.3]
b. 7 Jun 1920 d. 7 Jun 1920
10
Emma Addaline Yearsley
[1.1.1.3.7.2.8.8.2.4]
b. 20 Oct 1921 d. 10 Jan 2004
Frank Edell Smith
b. 15 Apr 1917 d. 7 Jul 1998
11
Daughter Smith
[1.1.1.3.7.2.8.8.2.4.1]
b. 20 Sep 1952 d. 20 Sep 1952
9
George Smith Ballif
[1.1.1.3.7.2.8.8.3]
b. 4 Jun 1894 d. 31 Oct 1977
Algie Eggertsen
b. 3 May 1896 d. 10 Jul 1984
10
Algene Ballif
[1.1.1.3.7.2.8.8.3.1]
b. 21 Sep 1924 d. 5 Apr 2014
10
Joan Ballif
[1.1.1.3.7.2.8.8.3.2]
b. 10 May 1926 d. 5 Jun 2013
10
George Eggertsen Ballif
[1.1.1.3.7.2.8.8.3.3]
b. 19 Jun 1927 d. 12 Jan 2003
9
Florence Ballif
[1.1.1.3.7.2.8.8.4]
b. 30 Sep 1896 d. 27 Dec 1947
Asael Carlyle Lambert
b. 8 Mar 1893 d. 1 Apr 1983
10
James Everard Lambert
[1.1.1.3.7.2.8.8.4.1]
b. 5 Feb 1916 d. 19 Nov 1999
+
Afton Hodson
b. 2 Jun 1914 d. 3 Dec 1940
Beverly Leggett
11
Richard C Lambert
[1.1.1.3.7.2.8.8.4.1.1]
b. 15 May 1924 d. 8 Jun 1980
10
Carlyle Ballif Lambert
[1.1.1.3.7.2.8.8.4.2]
b. 29 Jul 1917 d. Sep 2005
10
Edith Moselle Lambert
[1.1.1.3.7.2.8.8.4.3]
b. 11 May 1919 d. 23 Jul 1980
Mark Franklin Nielsen
b. 16 Aug 1910 d. 24 Nov 1995
11
Rebecca Deanne Nielsen
[1.1.1.3.7.2.8.8.4.3.1]
b. 9 Apr 1940 d. 8 Jun 2001
+
Thomas Sanborn, Jr
b. 30 May 1939 d. 1 Jun 2006
10
Ruth Lambert
[1.1.1.3.7.2.8.8.4.4]
b. 16 Dec 1920 d. 10 Feb 1989
10
John Baliff Lambert
[1.1.1.3.7.2.8.8.4.5]
b. 10 Oct 1926 d. 20 Aug 1931
10
Barbara Lambert
[1.1.1.3.7.2.8.8.4.6]
b. 10 Oct 1926 d. 21 May 2015
9
Margaret Elise Ballif
[1.1.1.3.7.2.8.8.5]
b. 24 Sep 1898 d. 17 Dec 1959
Frederick Barrett
b. 26 Mar 1891 d. 10 Jun 1976
10
Claramonde Barrett
[1.1.1.3.7.2.8.8.5.1]
b. 21 Apr 1916 d. 22 Sep 1980
10
Laverne Barrett
[1.1.1.3.7.2.8.8.5.2]
b. 11 Dec 1918 d. 25 Dec 1919
10
Frederick Barrett
[1.1.1.3.7.2.8.8.5.3]
b. 11 Feb 1921 d. 2 Jan 1999
+
Katheleen Devin
b. 30 Sep 1923 d. 4 Feb 1988
10
Margaret Barrett
[1.1.1.3.7.2.8.8.5.4]
b. 11 Feb 1921 d. 13 May 1973
+
Erle Raymond Madison
b. 11 May 1922 d. 6 Sep 1990
10
Emma Alice Barrett
[1.1.1.3.7.2.8.8.5.5]
b. 31 Jan 1924 d. 31 Jan 1924
10
Son Barrett
[1.1.1.3.7.2.8.8.5.6]
9
Ariel Smith Ballif
[1.1.1.3.7.2.8.8.6]
b. 9 Dec 1901 d. 11 May 1995
Artemesia Romney
b. 27 Aug 1904 d. 6 Feb 1993
10
Ariel Smith Ballif, Jr
[1.1.1.3.7.2.8.8.6.1]
b. 29 May 1926 d. 21 Apr 1994
10
Moana Ballif
[1.1.1.3.7.2.8.8.6.2]
b. 4 Jan 1928 d. 12 Apr 1988
9
Harriette Smith Ballif
[1.1.1.3.7.2.8.8.7]
b. 24 Jun 1904 d. 16 Jun 1982
William Theodore Berrett
b. 18 Nov 1899 d. 22 Apr 1987
10
Harriette Louise Berrett
[1.1.1.3.7.2.8.8.7.1]
b. 25 Dec 1926 d. 29 Dec 2008
Harold Douglas Hymas
b. 30 Oct 1919 d. 21 Jan 1996
11
Kelly Paul Hymas
[1.1.1.3.7.2.8.8.7.1.1]
b. 1 Aug 1958 d. 22 Nov 2000
10
Virgene Berrett
[1.1.1.3.7.2.8.8.7.2]
b. 26 Aug 1928 d. 19 Jun 2006
+
David Hirschi
b. 28 May 1925 d. 5 Oct 2009
10
Kathryn Ballif Berrett
[1.1.1.3.7.2.8.8.7.3]
b. 16 Oct 1931 d. 21 Mar 1965
+
Gene Edwin Barnes
b. 28 Mar 1928 d. 8 Mar 2011
8
Jennie Charlotte Ballif
[1.1.1.3.7.2.8.9]
b. 24 Jan 1868 d. 17 Aug 1946
Joseph Stewart Campbell
b. 29 Oct 1866 d. 8 May 1944
9
Jennie Ballif Campbell
[1.1.1.3.7.2.8.9.1]
b. 15 Jul 1895 d. 20 Jul 1916
9
Mary Campbell
[1.1.1.3.7.2.8.9.2]
b. 27 Mar 1899 d. 31 Mar 1976
Willard Riley Doxey
b. 22 Aug 1897 d. 31 Oct 1974
10
Willard Riley Doxey
[1.1.1.3.7.2.8.9.2.1]
b. 25 Jan 1925 d. 29 Nov 1961
Laurel Hinckley
b. 21 Mar 1927 d. 28 Dec 2011
11
Greg Charles Doxey
[1.1.1.3.7.2.8.9.2.1.1]
b. 17 Feb 1953 d. 8 Feb 2014
10
Elese Marie Doxey
[1.1.1.3.7.2.8.9.2.2]
b. 26 Nov 1926 d. 18 Oct 2016
10
Olive Jane Doxey
[1.1.1.3.7.2.8.9.2.3]
b. 22 Jun 1928 d. 14 May 2017
10
Son Doxey
[1.1.1.3.7.2.8.9.2.4]
b. 23 Dec 1936 d. 23 Dec 1936
9
Joseph Stewart Campbell
[1.1.1.3.7.2.8.9.3]
b. 6 Oct 1901 d. 18 May 1946
+
Mary Ensign
b. 28 Dec 1901 d. 10 Jul 1980
9
Dorothy Ballif Campbell
[1.1.1.3.7.2.8.9.4]
b. 11 Oct 1903 d. 23 Jun 1984
Archie Ozro Gardner
b. 27 Nov 1887 d. 18 May 1967
10
May Gardner
[1.1.1.3.7.2.8.9.4.1]
b. 23 May 1915 d. 1 Jul 2010
+
Ladd R Cropper
b. 6 May 1915 d. 10 Jul 2002
10
Owen Snow Gardner
[1.1.1.3.7.2.8.9.4.2]
b. 30 Jul 1918 d. 16 Mar 2003
11
Sydney Gardner
[1.1.1.3.7.2.8.9.4.2.1]
b. 4 May 1951 d. 19 Oct 2007
+
Cliofas Saucedo Torres
b. 7 Jul 1949 d. 21 Jan 2008
9
Lawrence Ballif Campbell
[1.1.1.3.7.2.8.9.5]
b. 29 Mar 1906 d. 4 Jul 1982
Dallas Lois Gibbons
b. 28 Aug 1908 d. 12 Dec 1999
10
Shirley Lois Campbell
[1.1.1.3.7.2.8.9.5.1]
b. 20 May 1932 d. 27 Aug 2003
10
Carolyn Dallas Campbell
[1.1.1.3.7.2.8.9.5.2]
b. 18 Nov 1933 d. 22 Mar 1995
9
Louise Harriett Campbell
[1.1.1.3.7.2.8.9.6]
b. 19 Oct 1911 d. 16 May 1978
6
Jean Louis Benedict Moinat
[1.1.1.3.7.3]
b. 3 Mar 1786 d. 16 Apr 1788
6
Jean Henri Moinat
[1.1.1.3.7.4]
b. 4 Nov 1787 d. 21 Dec 1846
+
Suzette Giradet
b. Abt 1787
Jeanne Suzanne Giradet
b. Abt 1786 d. 7 Feb 1822
7
Jeanne Marie Louise Moinat
[1.1.1.3.7.4.1]
b. 15 Apr 1818
7
Anne Louise Jeanne Marie Moinat
[1.1.1.3.7.4.2]
b. 7 Oct 1819
+
Marie Catherine Penevere
6
Jean Francois Louis Moinat
[1.1.1.3.7.5]
b. 29 Mar 1790 d. 26 Sep 1820
Jeanne Louise Pinget
b. 11 Jan 1790 d. 1 Apr 1868
7
Louise Meinat
[1.1.1.3.7.5.1]
b. 5 Oct 1818 bur. 22 Jun 1854
7
Henriette Marianne Moinat
[1.1.1.3.7.5.2]
b. 4 May 1820
6
Jean Louis Henry Moinat
[1.1.1.3.7.6]
b. 6 Apr 1794
6
Son Moinat
[1.1.1.3.7.7]
b. 12 Oct 1796 d. 12 Oct 1796
6
Jean Samuel Jacques Henri Moinat
[1.1.1.3.7.8]
b. 10 Apr 1798
Jeanne Susanne Ravessou
b. Abt 1798 d. 8 May 1822
7
Jean Jacques Henri Jules Moinat
[1.1.1.3.7.8.1]
b. 2 Nov 1818
7
Jean Jules Moinat
[1.1.1.3.7.8.2]
b. 15 May 1820
7
Marie Françoise Moinat
[1.1.1.3.7.8.3]
b. 21 Jan 1822
5
Henri Frederic Moinat
[1.1.1.3.8]
b. 1 Dec 1759
+
Jeanne Susanne Vialon
4
Francoise Thury
[1.1.1.4]
c. 16 Apr 1725
3
Pierre Thury
[1.1.2]
b. 28 Feb 1693