Home Page
|
What's New
|
Photos
|
Histories
|
Headstones
|
Reports
|
Surnames
Search
First Name:
Last Name:
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Suomalainen
Svenska
Reverend Thomas Peake
Abt 1605 - 1660 (55 years)
Submit Photo / Document
Individual
Descendants
Relationship
Timeline
Submit Photo / Doc
Worksheet
Family
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Reverend Thomas Peake
[1]
b. Abt 1605 d. 25 May 1660
Martha Whorwood
b. 1607
2
Anne Peake
[1.1]
b. 1630 d. 3 Sep 1671
Edward Elliston
c. 5 Oct 1630 d. 17 Mar 1706
3
Thomas Elliston
[1.1.1]
b. Bef 8 Jan 1656
3
Grace Elliston
[1.1.2]
b. Bef 8 Oct 1660
3
William Elliston
[1.1.3]
b. Bef 19 Feb 1661
3
Priscilla Elliston
[1.1.4]
b. Bef 7 Mar 1664
3
Joseph Elliston
[1.1.5]
Ann Chinnery
4
Edward Elliston
[1.1.5.1]
Elizabeth Daniel
5
Anne Elliston
[1.1.5.1.1]
b. 10 Jun 1739 d. Abt 27 Aug 1781
Thomas Ramplin
b. 1742
6
Anne Ramplin
[1.1.5.1.1.1]
b. 1762 d. 5 Oct 1844
William Rashbrook
b. Abt 1562
7
William Rashbrook
[1.1.5.1.1.1.1]
b. 1784
7
Joseph Rashbrook
[1.1.5.1.1.1.2]
b. 1787 d. 1876
7
Samuel Rashbrook
[1.1.5.1.1.1.3]
b. 1789 d. 1832
7
Susannah Rashbrook
[1.1.5.1.1.1.4]
b. 1791
7
Maria Rasbrook
[1.1.5.1.1.1.5]
b. 1798 d. 1854
7
Robert Rashbrook
[1.1.5.1.1.1.6]
b. 1800 d. 1868
7
Charles Rashbrook
[1.1.5.1.1.1.7]
b. 1805
Bemjamin Whiting
d. 1783
7
Ann Whiting
[1.1.5.1.1.1.8]
b. 1781 d. 1840
6
John Ramplin
[1.1.5.1.1.2]
b. 1764 bur. 9 Dec 1774
6
Richard Ramplin
[1.1.5.1.1.3]
c. 28 Jul 1764
6
Elizabeth Ramplin
[1.1.5.1.1.4]
c. 28 Dec 1770
6
Joseph Elliston Ramplin
[1.1.5.1.1.5]
c. 5 Mar 1772
6
Edward Ramplin
[1.1.5.1.1.6]
b. 1772 bur. 6 Jun 1772
6
Samuel Ramplin
[1.1.5.1.1.7]
b. 1777 bur. 27 May 1777
6
Thomas Ramplin
[1.1.5.1.1.8]
b. 5 Nov 1780
3
Edward Elliston
[1.1.6]
c. 24 Oct 1655 d. 1728
Mary Green
b. 1657
4
Henshaw Elliston
[1.1.6.1]
c. 11 Jul 1674 bur. 21 Feb 1758
Mary Underwood
b. 1679
5
Mary Elliston
[1.1.6.1.1]
b. 27 May 1703
John Nethergate
b. 19 Mar 1690
6
Edward Nethergate
[1.1.6.1.1.1]
b. Bef 1740 d. 4 May 1790
Sarah Wright
c. 29 Oct 1730 d. 12 Feb 1794
7
Edward Nethergate
[1.1.6.1.1.1.1]
c. 12 Apr 1762
7
John Neathergate
[1.1.6.1.1.1.2]
c. 5 Jan 1764
7
Sarah Nethergate
[1.1.6.1.1.1.3]
c. 20 May 1766 d. 25 Nov 1793
7
Ann Nethergate
[1.1.6.1.1.1.4]
c. 28 Feb 1768
7
Mary Nethergate
[1.1.6.1.1.1.5]
c. 17 Apr 1774
5
Henshaw Elliston
[1.1.6.1.2]
b. Abt 1705
4
Francis Elliston
[1.1.6.2]
b. 2 Nov 1676
4
Ambrose Elliston
[1.1.6.3]
b. 21 Jun 1681
4
Sarah Elliston
[1.1.6.4]
b. May 1683
4
George Elliston
[1.1.6.5]
b. Jul 1685 d. 4 Apr 1738
4
Ann Elliston
[1.1.6.6]
b. 24 Aug 1687
4
Pris Elliston
[1.1.6.7]
b. 14 Apr 1690
4
Kath Elliston
[1.1.6.8]
b. 1 May 1692 d. 3 Mar 1693
4
Mary Elliston
[1.1.6.9]
b. 19 Oct 1692
4
Martha Elliston
[1.1.6.10]
c. 12 Jan 1698
4
Robert Elliston
[1.1.6.11]
c. 20 Feb 1700 d. 11 Jul 1786
Elizabeth Harrington
c. 14 Aug 1712 d. 8 Nov 1774
5
Robert Elliston
[1.1.6.11.1]
c. 25 Feb 1729 d. 1783
Ester Hods
c. 9 May 1731
6
Robert Elliston
[1.1.6.11.1.1]
c. 29 Oct 1756
Mary Marsh
7
Mary Elliston
[1.1.6.11.1.1.1]
b. 1784 d. Bef 1786
7
Mary Elliston
[1.1.6.11.1.1.2]
c. 23 Mar 1786
7
Robert Elliston
[1.1.6.11.1.1.3]
b. 1791
Susannah Rout
b. Abt 1789
8
William Henry Elliston
[1.1.6.11.1.1.3.1]
c. 4 Apr 1825 d. 1901
Elizabeth Rebecca Beckwith
c. 11 Oct 1840
9
Ellen Elliston
[1.1.6.11.1.1.3.1.1]
9
William Henry Elliston
[1.1.6.11.1.1.3.1.2]
c. 6 Sep 1863 bur. 12 Nov 1863
9
William Henry Elliston
[1.1.6.11.1.1.3.1.3]
c. 7 May 1865
9
Kate Elliston
[1.1.6.11.1.1.3.1.4]
b. 1879
9
Albert Edward Edgar Elliston
[1.1.6.11.1.1.3.1.5]
b. 1881 d. 20 Jul 1956
Ada Maria Jackaman
b. 1881
10
Albert Rowland Elliston
[1.1.6.11.1.1.3.1.5.1]
b. 1905 d. 1980
Kengington
b. Abt 1905
11
Brian Elliston
[1.1.6.11.1.1.3.1.5.1.1]
b. 1946 d. 2006
10
Victor Henry Elliston
[1.1.6.11.1.1.3.1.5.2]
b. 1907 d. 1981
+
Grant
10
Thelma Elliston
[1.1.6.11.1.1.3.1.5.3]
b. 1912 d. 2001
+
Mills
b. Abt 1910
10
Barbara Elliston
[1.1.6.11.1.1.3.1.5.4]
b. 1921 d. 1981
+
Living
9
Edgar Elliston
[1.1.6.11.1.1.3.1.6]
7
Anna Elliston
[1.1.6.11.1.1.4]
c. 20 Jan 1792
7
James Elliston
[1.1.6.11.1.1.5]
c. 7 Feb 1794
6
Elizabeth Elliston
[1.1.6.11.1.2]
c. 22 Jun 1755
6
Henry Elliston
[1.1.6.11.1.3]
c. 14 Jan 1760 d. 1842
5
Thomas Elliston
[1.1.6.11.2]
c. 7 Mar 1730
Mary Powell
c. 9 Apr 1730
6
Mary Elliston
[1.1.6.11.2.1]
c. 16 Nov 1769
6
Isabella Elliston
[1.1.6.11.2.2]
c. 10 Dec 1770
5
Elizabeth Elliston
[1.1.6.11.3]
c. 5 Dec 1734 d. 1731
5
Edward Elliston
[1.1.6.11.4]
c. 9 Jun 1736
+
Mary Hill
b. Abt 1736
5
Barnabus Elliston
[1.1.6.11.5]
b. 1740 d. 1783
5
William Elliston
[1.1.6.11.6]
c. 4 Apr 1745 bur. 15 Feb 1829
Mary Segger Hankey
b. Abt 1755
6
William Elliston
[1.1.6.11.6.1]
c. 29 Sep 1777
6
Henry Elliston
[1.1.6.11.6.2]
6
Ann Elliston
[1.1.6.11.6.3]
c. 29 Sep 1779
6
Elizabeth Elliston
[1.1.6.11.6.4]
6
John Thomas Elliston
[1.1.6.11.6.5]
6
Fred Hankey Elliston
[1.1.6.11.6.6]
6
Edward Elliston
[1.1.6.11.6.7]
c. 18 Nov 1783 bur. 1 Apr 1845
Sophia Porter
c. 1813 d. 1893
7
Ann Porter
[1.1.6.11.6.7.1]
b. 1836
7
Emma Elliston
[1.1.6.11.6.7.2]
c. 1839 d. 1891
7
Henry Elliston
[1.1.6.11.6.7.3]
c. 1840
Sarah Mills
b. 1785 d. 1837
7
John Thomas Elliston
[1.1.6.11.6.7.4]
c. 14 Nov 1806 bur. 8 Apr 1866
Susan Deacon
b. 1805 d. 1868
8
Charles William Elliston
[1.1.6.11.6.7.4.1]
c. 3 Dec 1827
8
George Elliston
[1.1.6.11.6.7.4.2]
c. 12 Apr 1830
8
William Elliston
[1.1.6.11.6.7.4.3]
c. 14 Oct 1832 d. 12 Sep 1895
+
Eliza Snell
c. 14 Mar 1834 bur. 24 Mar 1886
8
Ann Elliston
[1.1.6.11.6.7.4.4]
c. 6 Mar 1835
William Snell
b. 17 Nov 1828
9
Susannah Snell
[1.1.6.11.6.7.4.4.1]
b. 1860
9
Elizabeth Ann Snell
[1.1.6.11.6.7.4.4.2]
b. 1863
9
Mary Ann Snell
[1.1.6.11.6.7.4.4.3]
b. 1864
9
William Thomas Snell
[1.1.6.11.6.7.4.4.4]
b. 1867
9
George Snell
[1.1.6.11.6.7.4.4.5]
b. 1871
9
Sarah Ann Snell
[1.1.6.11.6.7.4.4.6]
b. 1874
9
Ethel Snell
[1.1.6.11.6.7.4.4.7]
b. Abt 1882
8
Thomas John Elliston
[1.1.6.11.6.7.4.5]
b. 1837
Eunice
b. Abt 1845
9
Eunice Elliston
[1.1.6.11.6.7.4.5.1]
b. 1864
9
Thomas D Elliston
[1.1.6.11.6.7.4.5.2]
b. 1870
9
Edward C Elliston
[1.1.6.11.6.7.4.5.3]
b. 1870
9
Walter D Elliston
[1.1.6.11.6.7.4.5.4]
b. 1874
9
Harry O Elliston
[1.1.6.11.6.7.4.5.5]
b. 1876
9
Frederick W Elliston
[1.1.6.11.6.7.4.5.6]
b. 1878
9
Sarah Ann M Ellistone
[1.1.6.11.6.7.4.5.7]
b. 1880
8
Susannah Elliston
[1.1.6.11.6.7.4.6]
b. 1840 bur. 10 Mar 1859
8
John Deacon Elliston
[1.1.6.11.6.7.4.7]
b. 26 Jan 1842 d. 1860
8
Charles Elliston
[1.1.6.11.6.7.4.8]
b. 1844
Sarah
b. Abt 1847
9
Kessie S Ellistone
[1.1.6.11.6.7.4.8.1]
b. Abt 1867
8
Frederick Elliston
[1.1.6.11.6.7.4.9]
c. 13 Apr 1845 d. 1885
Hepzibah Gager
b. Abt 1836 d. 1912
9
Frederick Elliston
[1.1.6.11.6.7.4.9.1]
c. 6 Oct 1867
9
Susannah Elliston
[1.1.6.11.6.7.4.9.2]
c. 4 Apr 1869
9
Sophia Elliston
[1.1.6.11.6.7.4.9.3]
c. Apr 1871
9
William Elliston
[1.1.6.11.6.7.4.9.4]
c. 22 Jan 1873 d. 1905
9
Sarah Elliston
[1.1.6.11.6.7.4.9.5]
b. Abt 1874
9
Thomas Elliston
[1.1.6.11.6.7.4.9.6]
b. 1879 d. 6 Jun 1930
8
Joseph Robert Elliston
[1.1.6.11.6.7.4.10]
b. 1850
8
Donald Jay Elliston
[1.1.6.11.6.7.4.11]
7
Edward Gladwell Elliston
[1.1.6.11.6.7.5]
b. 14 May 1809 d. 1871
Mary Ann Coote
b. 1806 d. 1865
8
Sarah Ann Elliston
[1.1.6.11.6.7.5.1]
c. 5 Feb 1832 d. 9 Mar 1899
Robert Smith
9
Robert Smith
[1.1.6.11.6.7.5.1.1]
b. Abt 1856
9
William Smith
[1.1.6.11.6.7.5.1.2]
b. Abt 1858
9
Robert Smith
[1.1.6.11.6.7.5.1.3]
b. Abt 1860
9
Mary Ann Smith
[1.1.6.11.6.7.5.1.4]
b. Abt 1862
9
Edward Ernest Smith
[1.1.6.11.6.7.5.1.5]
b. Abt 1864
8
Mary Ann Elliston
[1.1.6.11.6.7.5.2]
c. 2 Feb 1834
Charles Mills
b. Abt 1834
9
Eliza Mills
[1.1.6.11.6.7.5.2.1]
b. Abt 1858
9
Charles H Mills
[1.1.6.11.6.7.5.2.2]
b. Abt 1860
9
Edward C Mills
[1.1.6.11.6.7.5.2.3]
b. 1870
8
Susan Elliston
[1.1.6.11.6.7.5.3]
b. 1836
8
William Elliston
[1.1.6.11.6.7.5.4]
b. 1837
8
Charles Elliston
[1.1.6.11.6.7.5.5]
b. 1839 d. 1846
8
Edward Elliston
[1.1.6.11.6.7.5.6]
b. 1841 d. 1844
8
Maria Elliston
[1.1.6.11.6.7.5.7]
b. 1843
+
Alfred H. Brown
b. Abt 1840
8
Henry Elliston
[1.1.6.11.6.7.5.8]
b. 1845 d. 14 Nov 1913
Eliza Etheridge
b. 1843 d. 8 Jul 1933
9
Edward Henry Elliston
[1.1.6.11.6.7.5.8.1]
b. 1871
8
Hannah Elliston
[1.1.6.11.6.7.5.9]
b. 1848 d. 1868
8
Frederick Elliston
[1.1.6.11.6.7.5.10]
b. 1850
7
Thomas Elliston
[1.1.6.11.6.7.6]
b. 21 Feb 1811 bur. 28 Apr 1813
7
Mary Ann Ellistone
[1.1.6.11.6.7.7]
b. 1812
James Ponder
b. 1816
8
Elizabeth Ponder
[1.1.6.11.6.7.7.1]
b. 1836
8
Ellen Matilda Ponder
[1.1.6.11.6.7.7.2]
b. 1836
8
Ann Maria Ponder
[1.1.6.11.6.7.7.3]
b. 7 Apr 1838
+
John Matthew Golding
b. Abt 1837
+
Jeramiah Thomas Garrard
b. 1845
8
Emma Ponder
[1.1.6.11.6.7.7.4]
b. 9 Feb 1841
8
Sophia Ponder
[1.1.6.11.6.7.7.5]
b. 10 Oct 1844
+
Henry Taggett
b. 1840
8
Walter Ponder
[1.1.6.11.6.7.7.6]
b. Abt 1854 d. 1876
7
Elizabeth Susan Elliston
[1.1.6.11.6.7.8]
c. 24 Jan 1815
+
Joseph Josling
b. Abt 1816
7
Joseph Elliston
[1.1.6.11.6.7.9]
c. 14 Aug 1816 d. 13 Jan 1901
Martha Berment
c. 1821 d. 1903
8
Sarah Elliston
[1.1.6.11.6.7.9.1]
b. 1839
8
William Elliston
[1.1.6.11.6.7.9.2]
b. 1841
+
Sarah Ducker
b. 1844
8
Joseph Elliston
[1.1.6.11.6.7.9.3]
b. 1845
8
George Elliston
[1.1.6.11.6.7.9.4]
b. 1846
8
Mary Elliston
[1.1.6.11.6.7.9.5]
b. 1849
8
Susan Elliston
[1.1.6.11.6.7.9.6]
b. 1851
8
Thomas Elliston
[1.1.6.11.6.7.9.7]
b. 1853
8
Jane Elliston
[1.1.6.11.6.7.9.8]
b. 1855
8
Edward Elliston
[1.1.6.11.6.7.9.9]
b. 1857
8
Charles Elliston
[1.1.6.11.6.7.9.10]
b. 1860
8
Frederick Elliston
[1.1.6.11.6.7.9.11]
b. 1862
8
Martha Elliston
[1.1.6.11.6.7.9.12]
b. 1865
7
James Elliston
[1.1.6.11.6.7.10]
c. 3 Dec 1817
7
Robert Elliston
[1.1.6.11.6.7.11]
b. 1819 d. Aft 1881
Elizabeth Claydon
b. 1819 d. 1885
8
Harry E Elliston
[1.1.6.11.6.7.11.1]
b. Dec 1859 bur. 16 Nov 1863
Ellen Willis
b. 1818 d. 1858
8
Harriet Elliston
[1.1.6.11.6.7.11.2]
c. 1845
Robert Mills
b. 1848
9
Ellen Mills
[1.1.6.11.6.7.11.2.1]
b. 1872
9
William Mills
[1.1.6.11.6.7.11.2.2]
b. Abt 1874
9
Arthur W Mills
[1.1.6.11.6.7.11.2.3]
b. Abt 1880
8
Ann Elliston
[1.1.6.11.6.7.11.3]
b. Abt 1846
8
Sarah Elliston
[1.1.6.11.6.7.11.4]
b. Abt 1848 d. 1891
8
Maria Elliston
[1.1.6.11.6.7.11.5]
b. 1850
8
Mary Elliston
[1.1.6.11.6.7.11.6]
b. 1855
8
Robert Elliston
[1.1.6.11.6.7.11.7]
b. 1856 d. 1870
8
Joseph Peter Elliston
[1.1.6.11.6.7.11.8]
b. 1858
8
William Elliston
[1.1.6.11.6.7.11.9]
b. 1866 d. 1890
Matilda Game
c. 31 Aug 1851
9
Ellen Elliston
[1.1.6.11.6.7.11.9.1]
b. Abt 1868
9
Elizabeth Elliston
[1.1.6.11.6.7.11.9.2]
b. Abt 1870
9
Robert William Elliston
[1.1.6.11.6.7.11.9.3]
b. 23 Sep 1873 d. Jun 1959
Katherine Louisa "Kate" Moore
b. 1877 d. 1955
10
Florence Kate Elliston
[1.1.6.11.6.7.11.9.3.1]
b. 1902 d. 1954
10
Rose Elliston
[1.1.6.11.6.7.11.9.3.2]
b. 1916 d. 1984
9
George Elliston
[1.1.6.11.6.7.11.9.4]
b. Abt 1876
9
Matilda Elliston
[1.1.6.11.6.7.11.9.5]
b. Abt 1880
7
Sarah Anne Elliston
[1.1.6.11.6.7.12]
b. Abt 1820
Samuel Boreham
b. Abt 1818
8
Susannah Boreham
[1.1.6.11.6.7.12.1]
b. 1839 d. 1839
8
Lydia Boreham
[1.1.6.11.6.7.12.2]
b. 1840
8
Emily Boreham
[1.1.6.11.6.7.12.3]
b. 1842 d. 1842
8
Robert Boreham
[1.1.6.11.6.7.12.4]
b. 1843
8
George Boreham
[1.1.6.11.6.7.12.5]
b. 1844 d. 1847
8
George Boreham
[1.1.6.11.6.7.12.6]
b. 1847 d. 1849
8
Caroline Boreham
[1.1.6.11.6.7.12.7]
b. 1850
8
Susannah Boreham
[1.1.6.11.6.7.12.8]
b. 1852
8
Fanny Boreham
[1.1.6.11.6.7.12.9]
c. 14 May 1854
8
Christina Boreham
[1.1.6.11.6.7.12.10]
b. 1856 d. 1857
8
Samuel Boreham
[1.1.6.11.6.7.12.11]
b. 1859 d. 1926
7
Anne Elliston
[1.1.6.11.6.7.13]
b. 1822
+
Isaac Ranson
b. 1815 bur. 28 Oct 1870
7
Susan Elliston
[1.1.6.11.6.7.14]
b. Abt 1824
7
Peter Smithson Elliston
[1.1.6.11.6.7.15]
c. 22 May 1826
Catherine Cousents
b. 1826
8
Sarah Ann Elliston
[1.1.6.11.6.7.15.1]
b. 1847
8
Martha Jane Elliston
[1.1.6.11.6.7.15.2]
b. 1850
8
George Elliston
[1.1.6.11.6.7.15.3]
b. 1859
8
Sophy Elliston
[1.1.6.11.6.7.15.4]
b. 1860
+
Herbert Sherdon
b. 1859
8
Robert Elliston
[1.1.6.11.6.7.15.5]
b. 1865
8
Harry Elliston
[1.1.6.11.6.7.15.6]
b. 1872
6
Mary Ann Elliston
[1.1.6.11.6.8]
c. 10 Dec 1794 d. 10 Aug 1795
4
Deborah Elliston
[1.1.6.12]
c. 19 Aug 1703
Sarah Clarke
c. 28 Nov 1652 d. 1697
4
Mary Elliston
[1.1.6.13]
c. 27 Apr 1678
4
Edward Elliston
[1.1.6.14]
c. 9 Jun 1680 d. 1737
Anna Blomfield
b. 1683 d. 1726
5
William Elliston
[1.1.6.14.1]
c. 21 Feb 1709 d. 1767
Mary Gray
b. 1712 d. 1777
6
John Elliston
[1.1.6.14.1.1]
c. 15 Oct 1732 d. 10 Nov 1738
6
William Elliston
[1.1.6.14.1.2]
b. 1732 d. 1807
6
Mary Elliston
[1.1.6.14.1.3]
b. 1734
Samuel Simson
d. 1783
7
Mary Simson
[1.1.6.14.1.3.1]
c. 5 Nov 1773
Benjamin King
b. 1764 d. 1848
8
Charlotte King
[1.1.6.14.1.3.1.1]
b. 1804 d. 1880
John Spurling
b. 1792 d. 1872
9
Charles Spurling
[1.1.6.14.1.3.1.1.1]
b. 1830
Mary McCallan
b. Abt 1830
10
John Robert Charles "Jack" Spurling
[1.1.6.14.1.3.1.1.1.1]
b. 1870 d. 1933
Helene Alice "Leni" Humble
b. 1869 d. 1952
11
Christian Donald "Chris" Spurling
[1.1.6.14.1.3.1.1.1.1.1]
b. 1904 d. 1993
6
Martha Elliston
[1.1.6.14.1.4]
b. 1736 d. 1822
Thomas Martin
b. 23 Sep 1735 d. 1825
7
John King Martin
[1.1.6.14.1.4.1]
b. 27 Aug 1774 d. 1849
6
Robert Elliston
[1.1.6.14.1.5]
b. 1752 d. 1800
Anne Martyn
b. 1752
7
Robert William Elliston
[1.1.6.14.1.5.1]
b. 7 Apr 1774 d. 8 Jul 1831
Elizabeth Randall
c. Abt 1775 d. 1 Apr 1821
8
Elizabeth Eliza Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.1]
b. 22 May 1797 d. 4 Apr 1874
Nicholas Lee Torre
b. 23 Jun 1795 d. 16 Sep 1867
9
Elizabeth Jane Torre
[1.1.6.14.1.5.1.1.1]
c. 16 Apr 1827 d. 28 Feb 1897
9
William Fox Whitebread Torre
[1.1.6.14.1.5.1.1.2]
b. 19 Feb 1829
9
Emma Frances Caroline Torre
[1.1.6.14.1.5.1.1.3]
b. 25 Nov 1831 d. 24 Dec 1861
9
Nicholas Kirkby Torre
[1.1.6.14.1.5.1.1.4]
b. 27 Apr 1833 d. 4 Mar 1892
Ann Butcher
c. 23 Dec 1827 d. 8 Jul 1904
10
Nicholas Henry George Torre
[1.1.6.14.1.5.1.1.4.1]
b. 1845
Frederica Mary Ford
b. 1855
11
Nicholas Arthur Ernest Torre
[1.1.6.14.1.5.1.1.4.1.1]
b. 1883 d. 1887
11
Lilian Maud Mary Torre
[1.1.6.14.1.5.1.1.4.1.2]
c. 6 Dec 1885 d. 1888
10
William Charles Kirkby Torre
[1.1.6.14.1.5.1.1.4.2]
b. 10 Dec 1853 d. 3 Aug 1923
Alice Annie Woodman
b. 16 Sep 1855 d. 7 Jan 1943
11
Harold Torre
[1.1.6.14.1.5.1.1.4.2.1]
b. 23 Nov 1879 d. 1941
+
Harriet Mary Clark
b. 4 Jul 1877 d. 3 Aug 1942
11
Dora Woodman Torre
[1.1.6.14.1.5.1.1.4.2.2]
b. 17 Dec 1880 d. 28 Feb 1953
Robert Norris Clark
b. 14 Jan 1875 d. 14 Dec 1965
12
Alice Edna Norris Clark
[1.1.6.14.1.5.1.1.4.2.2.1]
b. 17 Jul 1901 d. 27 Aug 1996
12
Dora Gwendoline Norris Clark
[1.1.6.14.1.5.1.1.4.2.2.2]
b. 1903
12
Ruby Harris Norris Clark
[1.1.6.14.1.5.1.1.4.2.2.3]
b. 1904 d. 1982
12
Kenneth Robert Charles Norris Clark
[1.1.6.14.1.5.1.1.4.2.2.4]
b. 8 Mar 1906 d. 26 Mar 1974
11
Ruth Emma Torre
[1.1.6.14.1.5.1.1.4.2.3]
b. 29 Nov 1884 d. 1959
11
Charles Leslie Torre
[1.1.6.14.1.5.1.1.4.2.4]
b. 15 Aug 1887 d. 8 Jul 1955
Kathleen Weatherburn Goodson
b. 1876 d. 1933
12
Myrtle Kathleen Torre
[1.1.6.14.1.5.1.1.4.2.4.1]
b. 1920 d. 1995
12
Geoffrey Charles Torre
[1.1.6.14.1.5.1.1.4.2.4.2]
b. 1922 d. 1991
11
Lucy Anita Torre
[1.1.6.14.1.5.1.1.4.2.5]
b. 16 Jan 1891 d. 1957
Knud Ernst Shaumburg-Muller
b. 1880 d. 1927
12
Sheila Violet Shaumburg-Muller
[1.1.6.14.1.5.1.1.4.2.5.1]
b. 1917 d. 1976
12
Living
[1.1.6.14.1.5.1.1.4.2.5.2]
12
Living
[1.1.6.14.1.5.1.1.4.2.5.3]
10
Eliza Emma Jane Torre
[1.1.6.14.1.5.1.1.4.3]
b. 11 Mar 1859 d. 1917
James Horne
b. 1858 d. 1937
11
Harriet Nancy Horne
[1.1.6.14.1.5.1.1.4.3.1]
b. 1896 d. 1968
10
Mildred Anne Charlotte Torre
[1.1.6.14.1.5.1.1.4.4]
b. 1 Apr 1861 d. 8 May 1861
10
Arthur James Elliston Torre
[1.1.6.14.1.5.1.1.4.5]
b. 1862 d. 1933
+
Emily Constance Potter
b. 1861 d. 1955
+
Rosabella Maria Jane Merryweather
b. 1876 d. 1946
10
Augusta Caroline Torre
[1.1.6.14.1.5.1.1.4.6]
c. 2 Sep 1864
Thomas Edmonds
b. 1854 d. 1933
11
Caroline Amy Edmonds
[1.1.6.14.1.5.1.1.4.6.1]
b. 1893 d. 1955
+
Leslie Austin Mudge
b. 1896 d. 1969
10
Charlotte Anne Mary Torre
[1.1.6.14.1.5.1.1.4.7]
b. Abt 1868 d. 1940
+
Henry Down
b. 1859 d. 1937
10
Frances Lettice Jane Torre
[1.1.6.14.1.5.1.1.4.8]
c. 20 Apr 1870 d. 1870
9
Constantine Edward Torre
[1.1.6.14.1.5.1.1.5]
b. 11 Jun 1834 d. 20 Aug 1851
9
Ferdinand James Torre
[1.1.6.14.1.5.1.1.6]
b. 28 Nov 1835
8
William Gore Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2]
b. 18 Oct 1798 d. 4 Dec 1872
Margaret de Vaux
b. 26 Nov 1807 d. 15 Nov 1873
9
Amelia Maria Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.1]
b. 20 Jan 1833 d. 1868
William Pitt
b. 15 Jun 1835 d. 1879
10
Francis William Pitt
[1.1.6.14.1.5.1.2.1.1]
b. 15 May 1860 d. 1929
+
Caroline Marion Millett
b. 1862
10
Sidney Herbert Pitt
[1.1.6.14.1.5.1.2.1.2]
b. 26 Mar 1862 d. 1890
10
William Pitt
[1.1.6.14.1.5.1.2.1.3]
b. 11 Apr 1864 d. 1891
10
Annie Gertude Pitt
[1.1.6.14.1.5.1.2.1.4]
b. 29 May 1866 d. 1919
Arthur Harold Glasgow
b. 1868 d. 1952
11
William Bernard Glasgow
[1.1.6.14.1.5.1.2.1.4.1]
b. 21 Sep 1891 d. 8 Jan 1991
+
Gwendoline Grace McKelvie Bull
b. 4 May 1896 d. 12 Mar 1980
11
Florence Marjorie Glasgow
[1.1.6.14.1.5.1.2.1.4.2]
b. 1893 d. 1966
+
John Connal Nicholson
b. 1883 d. 1972
11
Robert Elliston Glasgow
[1.1.6.14.1.5.1.2.1.4.3]
b. 1900 d. 1986
+
Mary Stuart Latter
b. 1900 d. 1986
+
Mona Millicent Elaine Whitney
b. 1914 d. Abt 2000
9
William Whiteford Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.2]
b. 20 May 1834 d. 27 Mar 1904
Henrietta Blacklow
b. 14 Jul 1835 d. 11 May 1920
10
Robert William Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.2.1]
b. 4 Jul 1864 d. 9 Jan 1943
+
Edith Edwina Luttrell
b. 1866 d. 1926
10
Edith Elizabeth Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.2.2]
b. 31 Dec 1865 d. 23 Mar 1875
10
Eva Matilda Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.2.3]
b. 17 Oct 1867 d. 5 Apr 1926
Frederick William Trappes
b. 1859 d. 6 Oct 1952
11
Owen Elliston Houston Trappes
[1.1.6.14.1.5.1.2.2.3.1]
b. 24 Feb 1899
11
Sheila Ernestine Trappes
[1.1.6.14.1.5.1.2.2.3.2]
b. 28 Mar 1901 d. 22 Apr 1985
11
Michael Trappes
[1.1.6.14.1.5.1.2.2.3.3]
b. 1903
11
Margaret Vaux Trappes
[1.1.6.14.1.5.1.2.2.3.4]
b. Abt 1905
11
Dulcie Catherine Trappes
[1.1.6.14.1.5.1.2.2.3.5]
b. Abt 1907
10
Ethel Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.2.4]
b. 25 Oct 1869 d. 22 Sep 1940
9
Charles Henry Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.3]
b. 29 Sep 1835 d. 28 Sep 1908
Lydia Elizabeth Compton
b. 28 Oct 1844 d. 5 Nov 1902
10
Vivian de Vaux Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.3.1]
b. 29 Mar 1864 d. 11 Oct 1934
Mary Harbottle
b. 1 Jul 1868 d. 1 Dec 1933
11
Charles Whitefoord Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.3.1.1]
b. 6 Feb 1892 d. 7 Mar 1941
Bessie Skinner
b. 23 Oct 1901 d. 28 Oct 1951
12
Living
[1.1.6.14.1.5.1.2.3.1.1.1]
12
Vivian Guy Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.3.1.1.2]
b. 3 Mar 1926 bur. 15 Aug 2008
12
Robin Charles Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.3.1.1.3]
b. 29 Mar 1929 bur. 7 Jul 2005
12
Ian James Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.3.1.1.4]
b. 2 Aug 1938 d. 5 Feb 1987
11
Vivian Guy Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.3.1.2]
b. 4 Sep 1893 d. 1982
+
Patricia Peebles
b. Abt 1693
+
Agnes
b. Abt 1693
+
Living
11
Dorothy Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.3.1.3]
b. 20 Oct 1895 d. 3 Apr 1983
Philip Reginald Seager
b. 27 Mar 1882 d. 7 Nov 1974
12
Living
[1.1.6.14.1.5.1.2.3.1.3.1]
12
Living
[1.1.6.14.1.5.1.2.3.1.3.2]
11
Nancy Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.3.1.4]
b. 9 Jan 1898 d. 23 Apr 1984
Eric Nelmes Bluck
b. Jan 1896 d. 5 Apr 1957
12
Living
[1.1.6.14.1.5.1.2.3.1.4.1]
12
Robert Nelmes Bluck
[1.1.6.14.1.5.1.2.3.1.4.2]
b. 1924 d. 2011
11
Mary Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.3.1.5]
b. 27 Sep 1901 d. 13 Jun 1971
+
John Harper Peate
b. 9 Mar 1906 d. 1 Sep 1995
11
Frank Harbottle Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.3.1.6]
b. 16 Feb 1903 d. 6 May 1905
11
Alice Beatrice Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.3.1.7]
b. 5 Oct 1905 d. 17 Mar 1993
+
Irwin Boyd Knight
b. 15 Jun 1906 d. 29 Mar 1981
10
Julia Edith Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.3.2]
b. 8 Jun 1865 d. 1938
10
Mabel Elizabeth Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.3.3]
b. 14 Jul 1867 d. 1932
John Armstrong Gourlay
b. 25 Aug 1857 d. 14 Dec 1895
11
Mary Eileen Gourlay
[1.1.6.14.1.5.1.2.3.3.1]
b. 1891 d. 1969
+
George Wilson Anderson
b. 1884 d. 1927
11
Alan John Elliston Gourlay
[1.1.6.14.1.5.1.2.3.3.2]
b. 22 Jun 1894 d. 1987
+
Olive Maud Whiteford
b. 1896 d. 1989
11
John Armstrong Gourlay
[1.1.6.14.1.5.1.2.3.3.3]
b. 1895 d. 1968
Enid Graham Wilson
b. 1900 d. 1989
12
John Wilson Gourlay
[1.1.6.14.1.5.1.2.3.3.3.1]
b. 1934 d. 2007
+
Arthur Clayton Morrisby
b. 24 Sep 1872 d. 27 Apr 1952
10
Rosalind Victoria Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.3.4]
b. 24 May 1869 d. 1935
George William Francis
b. 1863 d. 1943
11
Shirley Elliston Francis
[1.1.6.14.1.5.1.2.3.4.1]
b. 1896 d. 1956
Constance Mary Varley
b. 1898 d. 1972
12
Charles Hugh Francis
[1.1.6.14.1.5.1.2.3.4.1.1]
b. 15 Jul 1924 d. 14 Aug 2009
10
Herbert Russell Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.3.5]
b. 8 Nov 1870 d. 13 Jan 1944
Florence May Love
b. Abt 1873
11
Neil Russell Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.3.5.1]
b. 8 May 1904
10
Walter Marmaduke Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.3.6]
b. 11 Feb 1873 d. 11 Apr 1944
Ada Elizabeth Dart
b. 1 Jun 1875 d. 18 Apr 1927
11
Muriel Isobel Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.3.6.1]
b. 29 Nov 1896 d. 14 Oct 1971
11
John Graham Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.3.6.2]
b. 16 Feb 1913
+
Maude Evelyn Thompson
b. Abt 1874
10
Ruby Muriel Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.3.7]
b. 9 Sep 1875
Hamilton John Spier
b. Abt 1875
11
Ruth Elliston Spier
[1.1.6.14.1.5.1.2.3.7.1]
b. 1907 d. 1962
+
Drury Clarke
b. Abt 1907
+
Kenneth Andrew Kirkwood
b. Abt 1907
11
Peter Elliston Spier
[1.1.6.14.1.5.1.2.3.7.2]
b. 1909 d. 1974
+
Janet Sinclair Elizabeth Mary Stewart
b. 1907 d. 1984
10
Charles Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.3.8]
b. 9 Apr 1877 d. 24 Apr 1877
10
Beatrice Violet Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.3.9]
b. 18 May 1878
Sidney Arthur Perry
b. Abt 1878
11
Richard Charles Perry
[1.1.6.14.1.5.1.2.3.9.1]
b. 1909 d. 1983
+
Living
11
Living
[1.1.6.14.1.5.1.2.3.9.2]
+
Living
+
Living
+
Frank Sydney Edwards
b. 1909 d. 1992
10
Margaret Coralie Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.3.10]
b. 18 Jun 1879 d. Aft 1935
10
Lillian Maud Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.3.11]
b. 22 Sep 1880 d. 14 Jan 1881
10
Amabel Evelyn Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.3.12]
b. 8 Nov 1881 d. 21 Jul 1959
+
Reginald Ernest Ransom
b. 1870 d. 1959
10
Charles Oswald Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.3.13]
b. 27 Dec 1884 d. 31 Mar 1885
10
Marcia Fay Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.3.14]
b. 10 Feb 1886 d. 1969
Fritz George Heyer
b. 1878 d. 1934
11
Winifred Fay Heyer
[1.1.6.14.1.5.1.2.3.14.1]
b. 1913 d. 1991
+
Eric Piper
d. 1942
+
Richard Evans
11
John Whitefoord Heyer
[1.1.6.14.1.5.1.2.3.14.2]
b. 1916 d. 2001
9
Henry Robert Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.4]
b. 18 Jun 1837 d. 11 Apr 1838
9
Julia Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.5]
b. 6 Dec 1838 d. 2 May 1876
John James Butler
b. 7 Feb 1828 d. 18 Dec 1896
10
Frances Ethel Butler
[1.1.6.14.1.5.1.2.5.1]
b. 15 Aug 1860 d. 17 Jan 1951
+
Ernest Alfred Pavitt
b. 29 Jun 1856 d. 15 May 1945
10
Helen Maud Butler
[1.1.6.14.1.5.1.2.5.2]
b. 11 Mar 1862 d. 25 Nov 1933
10
Maria Dorothea Butler
[1.1.6.14.1.5.1.2.5.3]
b. 13 Nov 1863 d. 13 Sep 1956
10
Margaret Amelia Butler
[1.1.6.14.1.5.1.2.5.4]
b. 15 Sep 1865 d. 28 Apr 1914
10
Mabel Butler
[1.1.6.14.1.5.1.2.5.5]
b. 26 Nov 1867 d. 15 Sep 1952
Frank Whistler Butler
b. 1865 d. 29 Feb 1936
11
James Whistler Butler
[1.1.6.14.1.5.1.2.5.5.1]
b. 17 Jun 1898 d. 15 May 1978
+
Helen Beatrix Dickinson
b. 8 Apr 1903 d. 5 Nov 1978
10
Florence Rose Butler
[1.1.6.14.1.5.1.2.5.6]
b. 20 Dec 1869 d. 29 Jun 1944
+
Houston Patterson Wallace Rooke
b. Sep 1869 d. 21 Aug 1948
10
John Leslie Butler
[1.1.6.14.1.5.1.2.5.7]
b. 14 Sep 1871 d. 8 Oct 1945
Isabella Roe
b. 1865 d. 1947
11
John Doughty Butler
[1.1.6.14.1.5.1.2.5.7.1]
b. 7 Jan 1897 d. 1985
+
Marjorie Eleanor Wettenhall
b. 1904 d. 1988
11
Benjamin Roe Butler
[1.1.6.14.1.5.1.2.5.7.2]
b. 1898
+
Mary Charles
b. Abt 1898
11
Daughter Butler
[1.1.6.14.1.5.1.2.5.7.3]
b. 26 Dec 1901
11
Joyce Margaret Doughty Butler
[1.1.6.14.1.5.1.2.5.7.4]
b. 14 Jun 1903
10
Percival de Vaux Butler
[1.1.6.14.1.5.1.2.5.8]
b. 6 Dec 1873 d. 29 Mar 1954
Florence Aubrey Weston
b. 3 Jan 1875 d. Mar 1959
11
Nea Weston Butler
[1.1.6.14.1.5.1.2.5.8.1]
b. 27 May 1898
10
Henry Walter Butler
[1.1.6.14.1.5.1.2.5.9]
b. 2 May 1876 d. 3 Jan 1877
9
Albina Lucy Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.6]
b. 23 Jun 1840 d. 4 Jul 1917
Hauraki Hereward Maning
b. 1845 d. 8 Aug 1923
10
Frederick Edward Hauraki Maning
[1.1.6.14.1.5.1.2.6.1]
b. 1888 d. Oct 1955
9
Daughter Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.7]
b. 1842 d. 1842
9
Walter Frederick Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.8]
b. 3 Sep 1843 d. 17 Aug 1865
9
Robert Lowes Victor Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.9]
b. 24 Aug 1845 d. 2 Jan 1914
+
Jane Fahlborg
b. 1849 d. 1918
Maria Lavinia Blacklow
b. 24 Aug 1855 d. 8 Jun 1891
10
Gertrude Caroline Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.9.1]
b. 25 Jul 1877
Charles Purdy
b. Abt 1877
11
Laurie Purdy
[1.1.6.14.1.5.1.2.9.1.1]
b. Abt 1897
10
Charles Edmund Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.9.2]
b. 4 Sep 1878 d. 1957
Josephine Annie Fahlborg
b. 3 Aug 1880 d. 15 Oct 1966
11
Robert William Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.9.2.1]
b. 1904 d. 1988
+
Winifred Lynette Utber
b. 1906
11
Noel Charles Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.9.2.2]
b. 1908 d. Jul 1978
+
Living
11
Nancy May Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.9.2.3]
b. 1913
+
Herbert Reginald Whiter
b. Abt 1912
+
Douglas Ford
b. Abt 1912
10
Alberta Maud Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.9.3]
b. 25 Oct 1879 d. 1960
Raymond Clarke Morrisby
b. 26 May 1879 bur. 25 Oct 1934
11
Margaret de Vaux Morrisby
[1.1.6.14.1.5.1.2.9.3.1]
b. 1904 d. 1978
+
Antonio Louez
b. Abt 1900
+
Arthur John Lovett
b. Abt 1900
11
Reginald Colin Morrisby
[1.1.6.14.1.5.1.2.9.3.2]
b. 1906 d. 1984
+
Lucy Amelia Laufer
b. 1907 d. 1987
10
William Gore Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.9.4]
b. 21 Dec 1881 d. 1961
Evelyn Joel Oppenheim
b. 1880 d. 1951
11
Kathleen Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.9.4.1]
b. 2 Jan 1914 d. 22 Dec 1994
+
James Sydney Todd Stevens
b. 1907 d. 1982
11
Cyril Herbert Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.9.4.2]
b. 1915 d. 1989
+
Living
11
Living
[1.1.6.14.1.5.1.2.9.4.3]
+
Vincent Rockliff Abey
b. 1910 d. 1967
11
Maxwell Gore Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.9.4.4]
b. 1918 d. 1984
11
Living
[1.1.6.14.1.5.1.2.9.4.5]
+
Living
+
Olive May "Fish" Foster
b. Abt 1890
10
John Wentworth Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.9.5]
b. 8 Apr 1884 d. Aft 1914
10
Marjorie Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.9.6]
b. 2 Mar 1886 d. 1977
Gordon Cyril Adams
b. 28 Jan 1881 d. 14 Aug 1970
11
Alan Elliston Adams
[1.1.6.14.1.5.1.2.9.6.1]
b. 10 Apr 1910 d. 30 Mar 1985
+
Blanche Stubbs
b. 8 Jan 1900 d. 25 Nov 1953
+
Elizabeth Morey Nelson
d. 1969
+
Living
11
Malcolm Elliston Adams
[1.1.6.14.1.5.1.2.9.6.2]
b. 1911 d. 1977
+
Marjorie Gordon Douglas
b. 1914
11
Dorothy Isobel Adams
[1.1.6.14.1.5.1.2.9.6.3]
b. 1914
+
Geoffrey Edmund Allen
b. 1914
11
Living
[1.1.6.14.1.5.1.2.9.6.4]
+
Living
11
Living
[1.1.6.14.1.5.1.2.9.6.5]
+
Leslie Stuart Douglas
b. 1924 d. 1990
11
Living
[1.1.6.14.1.5.1.2.9.6.6]
+
Living
10
George Frederick Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.9.7]
b. 18 Jul 1888 d. 1950
Florence Annie Fagan
b. 1887 d. 1973
11
Warwick Roland Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.9.7.1]
b. 13 Feb 1922 d. Abt 1990
+
Living
11
Gordon Noel Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.9.7.2]
b. 23 Jul 1925 d. 11 Mar 2016
Living
12
Kathy Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.9.7.2.1]
[
=>
]
+
Addeen Forlong Snow
b. 1930 d. 1987
10
Child Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.9.8]
b. 8 Jun 1891 d. 8 Jun 1891
9
Eliza Jane Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.10]
b. 5 Dec 1846 d. 19 Oct 1934
Charles Stephen Grueber
b. 23 Sep 1849
10
Archibald Harold Grueber
[1.1.6.14.1.5.1.2.10.1]
b. 10 Dec 1873 d. 5 Aug 1952
Edith May Williams
b. 8 Jul 1880 d. 1953
11
Enid Estelle May Grueber
[1.1.6.14.1.5.1.2.10.1.1]
b. 11 Jan 1904 d. 1993
+
Edgar William Gordon "Horrie" Foster
b. 1902 d. 11 Jun 1988
11
Ruby Vine Grueber
[1.1.6.14.1.5.1.2.10.1.2]
b. 29 Mar 1906 d. 28 Feb 1990
+
William Reed
b. Abt 1905 d. 25 Apr 1993
11
Coral Elliston Grueber
[1.1.6.14.1.5.1.2.10.1.3]
b. 1912
Gordon Keith Thewlis
b. 1913 d. 29 May 1961
12
Living
[1.1.6.14.1.5.1.2.10.1.3.1]
+
Trevor Fryer
b. Abt 1911 d. 17 Feb 1986
11
Edith Jean Grueber
[1.1.6.14.1.5.1.2.10.1.4]
b. 16 Aug 1916 d. 18 Sep 1979
+
Geoffrey Ernest Gordon Harvey
b. 30 Jan 1913
11
Frank William Grueber
[1.1.6.14.1.5.1.2.10.1.5]
b. 24 Mar 1922 d. 7 Jan 1977
+
Alison Isobel Henderson
b. Abt 1922 d. 17 Feb 1971
+
Living
10
Son Grueber
[1.1.6.14.1.5.1.2.10.2]
b. Abt 1874
10
Francis William Grueber
[1.1.6.14.1.5.1.2.10.3]
b. 10 Jan 1876 d. 1968
Frances May Gage
b. 24 May 1873
11
Marguerite Frances Grueber
[1.1.6.14.1.5.1.2.10.3.1]
b. 1904 d. 1993
+
Dudley Smith
b. Abt 1903
+
Stuart Ellis Atkins Pixley
b. Abt 1904 d. 1982
11
Kathleen Isobel Southern Grueber
[1.1.6.14.1.5.1.2.10.3.2]
b. 1905 d. 1992
+
Kenneth Guy Andrewartha
b. 11 May 1902 d. 1993
11
Francis Marcus John Gage Grueber
[1.1.6.14.1.5.1.2.10.3.3]
b. 26 May 1914 d. 23 May 1996
+
Kathleen May Gillam
b. 1914
+
Living
10
Harry Elliston Grueber
[1.1.6.14.1.5.1.2.10.4]
b. 13 May 1877 d. 1946
+
Annie Louisa McWilliams
10
Son Grueber
[1.1.6.14.1.5.1.2.10.5]
b. Abt 1878
10
Walter Frederick Grueber
[1.1.6.14.1.5.1.2.10.6]
b. 15 Dec 1879 d. 1968
+
Ethel Elizabeth Willy
b. 1886 d. 1973
10
Son Grueber
[1.1.6.14.1.5.1.2.10.7]
b. Abt 1880
10
Charles Clifford Grueber
[1.1.6.14.1.5.1.2.10.8]
b. 1882 d. 1948
+
Hilda Frances Allison
b. Abt 1882
10
Stephen Howard Grueber
[1.1.6.14.1.5.1.2.10.9]
b. 12 Nov 1886 d. 22 Apr 1964
Margarete Anne Preston Dechaineux
b. 7 Apr 1894 d. 1985
11
Stephen Emile Gruncher
[1.1.6.14.1.5.1.2.10.9.1]
11
Rosemary Elaine Gruncher
[1.1.6.14.1.5.1.2.10.9.2]
11
Ella Dawn Greuber
[1.1.6.14.1.5.1.2.10.9.3]
10
Arthur Gordon Grueber
[1.1.6.14.1.5.1.2.10.10]
b. 17 Sep 1889 d. 1976
Mary Sophia Roe Mitchell
b. Abt 1789
11
Erroll William Grueber
[1.1.6.14.1.5.1.2.10.10.1]
b. 1924 d. 1968
+
Living
11
Living
[1.1.6.14.1.5.1.2.10.10.2]
+
Living
9
Margaret Isabel Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.2.11]
b. 24 Jul 1849 d. 1854
8
Frances Maria Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.3]
b. 13 Aug 1800 d. 21 Mar 1853
Marmaduke Charles Wilson
b. 29 Nov 1796 d. 29 May 1876
9
Harriet Maria Wilson
[1.1.6.14.1.5.1.3.1]
b. 5 Mar 1823 d. 1900
9
Robert Marmaduke Wilson
[1.1.6.14.1.5.1.3.2]
c. 1 Mar 1828 d. 1834
9
Charles Wathen Elliston Wilson
[1.1.6.14.1.5.1.3.3]
b. 29 Sep 1829 d. 1902
9
Annette Eliza Wilson
[1.1.6.14.1.5.1.3.4]
b. 1835 d. 1902
9
Meta Rundall Wilson
[1.1.6.14.1.5.1.3.5]
b. 1840 d. 1864
+
Charles Edmund Turle
9
Emma Mary Anne Jane Wilson
[1.1.6.14.1.5.1.3.6]
b. 1841 d. Aft 1860
+
Robert Westgarth Taylor
b. 1848 d. 1884
8
Henry Twisleton Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.4]
b. 4 Jan 1802
8
Charles Robert Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.5]
b. 5 Nov 1804 d. 1872
Floriaanne Marie Lea
b. 1830 d. 1851
9
Florian Charles Henry Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.5.1]
b. 1851 d. 1897
8
Albina Jane Martyn Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.6]
b. 10 Mar 1808 d. 1891
John Whitefoord
b. 1808 d. 1891
9
Jane Maria Whitefoord
[1.1.6.14.1.5.1.6.1]
b. 1833 d. 23 Sep 1902
+
Thomas Stephens
b. 4 Oct 1830 d. 25 Nov 1913
9
John Whitefoord
[1.1.6.14.1.5.1.6.2]
b. 1835 d. 1842
9
Caleb Whitefoord
[1.1.6.14.1.5.1.6.3]
b. 1837 d. 1891
+
Rebekah Wills
b. 1840 d. 1910
9
Charles Whitefoord
[1.1.6.14.1.5.1.6.4]
b. 1839 d. 1872
9
Lucy Harriet Whitefoord
[1.1.6.14.1.5.1.6.5]
b. 1841 d. 1896
Charles Wilfred Seymour Chamberlain
b. 1843 d. 1929
10
Charles Whitefoord John Chamberlain
[1.1.6.14.1.5.1.6.5.1]
b. 15 Jan 1874 d. 1904
9
Alan Whitefoord
[1.1.6.14.1.5.1.6.6]
b. 1843 d. 1883
Margaret Helena Keene
b. 1843 d. 1914
10
Morton Whitefoord
[1.1.6.14.1.5.1.6.6.1]
b. 1869 d. 1914
10
Nina Mary Whitefoord
[1.1.6.14.1.5.1.6.6.2]
b. 1878 d. 1879
10
Caleb Cranston Whitefoord
[1.1.6.14.1.5.1.6.6.3]
b. 1880 d. 1880
9
Adam Elliston Whitefoord
[1.1.6.14.1.5.1.6.7]
b. 1847 d. 1894
8
Mary Juliet Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.7]
b. 21 Jul 1809 d. 5 Sep 1811
8
Lucy Ann Theresa Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.8]
b. 21 Dec 1811 d. 28 Jan 1831
8
Edmund Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.9]
b. 17 Sep 1813 d. 1869
Emma Alexandra Gledhill
b. 1815
9
Mary Anne Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.9.1]
b. 16 Nov 1839 d. 1918
9
Robert William Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.9.2]
b. 7 Jan 1842 d. 26 Oct 1926
Ellen Margaret Donnison
b. 19 Apr 1859 d. 4 Mar 1952
10
Ada Muriel Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.9.2.1]
b. 31 Dec 1881 d. 1965
Wyndham Ernest Hart
b. 1877 d. 1965
11
Hilda Margaret Hart
[1.1.6.14.1.5.1.9.2.1.1]
b. 31 Jul 1909 d. 1990
Maurice Charles Beevor Steele
b. 13 Jan 1904 d. 2 Feb 1973
12
Patricia Steele
[1.1.6.14.1.5.1.9.2.1.1.1]
b. 19 Jul 1934 d. 4 Jul 2014
11
Geoffrey Wyndham Hart
[1.1.6.14.1.5.1.9.2.1.2]
b. Abt 1910
+
Nesta
b. Abt 1910
11
Dorothy Mary Hart
[1.1.6.14.1.5.1.9.2.1.3]
b. 10 Oct 1913 d. 18 Jul 2008
Brigadier General Lionel Johnson Wood, CBE
b. 27 Apr 1907 d. 1977
12
Richard Geoffrey Wood
[1.1.6.14.1.5.1.9.2.1.3.1]
b. 22 Jun 1945 d. 9 Mar 2014
12
Living
[1.1.6.14.1.5.1.9.2.1.3.2]
[
=>
]
10
Gladys Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.9.2.2]
b. 6 Jun 1883 d. 21 Aug 1957
10
Dorothy Gledhill Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.9.2.3]
b. 28 Aug 1884 d. 9 Mar 1964
+
Peter Anthony O'brien
b. Abt 1888
10
Robert William Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.9.2.4]
b. 21 Jul 1886 d. 21 Jul 1886
10
Lilian Oldaker Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.9.2.5]
b. 17 May 1889 d. 1987
Frederick Keith Jackson
b. 1891 d. 1988
11
Alan Keith Jackson
[1.1.6.14.1.5.1.9.2.5.1]
b. 1925 d. 1988
11
Living
[1.1.6.14.1.5.1.9.2.5.2]
+
Living
+
Living
11
Living
[1.1.6.14.1.5.1.9.2.5.3]
+
Francis George Campbell
b. 1923 d. 1987
9
Edmund Charles Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.9.3]
b. 1843 d. 1928
+
Elizabeth Julia Parker
b. 1873 d. 1944
+
Amy Caroline Taylor
b. 1843 d. 1915
9
Henry Rundall Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.9.4]
b. 1845 d. 1912
9
Emma Frances Ewing Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.9.5]
b. 1851 d. 1919
9
Percival Marmaduke Charles Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.9.6]
c. 23 Feb 1857 d. 1860
8
Mary Anne Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.10]
b. 10 Nov 1817
Isabella Alleia Wright
b. Abt 22 Oct 1783 d. Abt 12 Apr 1844
8
William Henry Elliston Wilmot
[1.1.6.14.1.5.1.11]
b. 1806 d. 5 Dec 1842
Eliza Mary Best
b. 1806 d. 21 Jul 1871
9
Georgine Jane Wilmot
[1.1.6.14.1.5.1.11.1]
b. 30 Apr 1830 d. 6 Aug 1880
Charles Butler
b. 1 Jul 1820 d. 8 Jul 1909
10
Georgina Kate Butler
[1.1.6.14.1.5.1.11.1.1]
b. 6 Dec 1849 d. 10 Oct 1929
Brigadier Alexander Temple Cox
b. 29 Jan 1836 d. 5 Apr 1907
11
Winnifred Jua Temple Cox
[1.1.6.14.1.5.1.11.1.1.1]
b. 24 Jun 1880
+
Claude Hardinge Hill
b. 1882 d. 1960
11
Guy Alex Temple Cox
[1.1.6.14.1.5.1.11.1.1.2]
b. 15 Feb 1882 d. 1951
Margaret Cumming Ince
b. 1894 d. 1954
12
Margaret Patricia Temple-Cox
[1.1.6.14.1.5.1.11.1.1.2.1]
12
Living
[1.1.6.14.1.5.1.11.1.1.2.2]
11
Joan Mary Temple Cox
[1.1.6.14.1.5.1.11.1.1.3]
b. 5 Feb 1884 d. 1965
Ronald Macpherson Harvey
b. 1888 d. 1968
12
John Aberdein Harvey
[1.1.6.14.1.5.1.11.1.1.3.1]
b. 3 May 1918 d. 1982
12
Living
[1.1.6.14.1.5.1.11.1.1.3.2]
12
Mary Angelica Harvey
[1.1.6.14.1.5.1.11.1.1.3.3]
b. 4 Apr 1920 d. 1979
12
Living
[1.1.6.14.1.5.1.11.1.1.3.4]
12
Ronald Alexander Harvey
[1.1.6.14.1.5.1.11.1.1.3.5]
b. 6 Dec 1923 d. 5 Jun 1939
11
Phyllis Temple Cox
[1.1.6.14.1.5.1.11.1.1.4]
b. 28 Feb 1886 d. 1963
Richard Francis Morris
b. 1874 d. 1946
12
Barbara Phyllis Morris
[1.1.6.14.1.5.1.11.1.1.4.1]
b. 1915 d. 1994
12
Richard Morris
[1.1.6.14.1.5.1.11.1.1.4.2]
b. 1917 d. Abt 1941
12
Anthony Charles Temple Morris
[1.1.6.14.1.5.1.11.1.1.4.3]
b. 1919 d. 1986
10
Edward Henry Butler
[1.1.6.14.1.5.1.11.1.2]
b. 15 Mar 1851 d. 1928
Fanny Amy Clerk
b. 14 May 1861
11
Edward Lionel Austin Butler
[1.1.6.14.1.5.1.11.1.2.1]
b. 1884 d. 23 Aug 1915
11
Angus Leicester Butler
[1.1.6.14.1.5.1.11.1.2.2]
b. 30 Jun 1885 d. 1965
+
Marjorie Ellis
11
Hugh Robert Butler
[1.1.6.14.1.5.1.11.1.2.3]
b. 20 Nov 1887 d. 18 Feb 1888
10
Lucy Madeline Butler
[1.1.6.14.1.5.1.11.1.3]
b. 22 Nov 1852
Edward Bean
b. 1851 d. 1922
11
Madeline Jessie Bean
[1.1.6.14.1.5.1.11.1.3.1]
b. 4 May 1878 d. 8 Jan 1879
11
Charles Edwin Woodrow Bean
[1.1.6.14.1.5.1.11.1.3.2]
b. 18 Nov 1879 d. 30 Aug 1968
11
John Willoughby Butler Bean
[1.1.6.14.1.5.1.11.1.3.3]
b. 1 Jan 1881
11
Montague Butler Bean
[1.1.6.14.1.5.1.11.1.3.4]
b. 30 Jul 1884
10
Charles William Butler
[1.1.6.14.1.5.1.11.1.4]
b. 18 Sep 1854 d. 10 Jun 1937
Beatrice Maria Travers
b. 22 Apr 1858 d. 27 Jun 1936
11
Marjorie Travers Butler
[1.1.6.14.1.5.1.11.1.4.1]
b. 15 May 1883 d. 9 Sep 1972
11
Beatrice Travers Butler
[1.1.6.14.1.5.1.11.1.4.2]
b. 10 Aug 1884 d. 13 Oct 1969
11
Archiblad Travers Butler
[1.1.6.14.1.5.1.11.1.4.3]
b. 28 Dec 1885 d. 24 Feb 1886
11
Son Butler
[1.1.6.14.1.5.1.11.1.4.4]
b. 28 Dec 1885
11
Charles Travers Butler
[1.1.6.14.1.5.1.11.1.4.5]
b. 10 Nov 1887 d. 1974
Katharine Angel Keva Allardyce
b. 10 Jun 1898 d. 13 Sep 1979
12
Katharine Ann Allardyce Butler
[1.1.6.14.1.5.1.11.1.4.5.1]
b. 2 Oct 1925 d. 4 Jun 2002
12
Charles Christopher Allardyce Butler
[1.1.6.14.1.5.1.11.1.4.5.2]
b. 6 Jun 1927 d. 11 Nov 2000
12
Jamie Butler
[1.1.6.14.1.5.1.11.1.4.5.3]
b. 30 Nov 1929 d. Dec 2011
11
Geoffrey Travers Butler
[1.1.6.14.1.5.1.11.1.4.6]
b. 15 Mar 1890
11
Leicester Travers Butler
[1.1.6.14.1.5.1.11.1.4.7]
b. 18 Jan 1894
11
James Montagu Travers Butler
[1.1.6.14.1.5.1.11.1.4.8]
b. 9 Aug 1896
10
Frances Leicester Butler
[1.1.6.14.1.5.1.11.1.5]
b. 28 Feb 1856 d. 1885
10
Ida Mary Butler
[1.1.6.14.1.5.1.11.1.6]
b. 10 Nov 1861 d. 1949
Alexander McAuley
b. 9 Nov 1863 d. 1931
11
Ida Sowerby McAuley
[1.1.6.14.1.5.1.11.1.6.1]
b. 23 Jan 1858 d. 15 Oct 1949
11
Alexander Leicester McAuley
[1.1.6.14.1.5.1.11.1.6.2]
b. 15 Nov 1895 d. 10 Apr 1969
10
Leila Chalmers Butler
[1.1.6.14.1.5.1.11.1.7]
b. 24 Nov 1859
10
May Maria Butler
[1.1.6.14.1.5.1.11.1.8]
b. 3 Nov 1861 d. 14 Nov 1951
10
Herbert Maxwell Butler
[1.1.6.14.1.5.1.11.1.9]
b. 2 Oct 1863 d. 1925
+
Amy Isobel Rogers
b. 1871 d. 1962
10
Montagu Howard Butler
[1.1.6.14.1.5.1.11.1.10]
b. 21 Mar 1868 d. 1895
9
Eliza Elliston Wilmot
[1.1.6.14.1.5.1.11.2]
b. 18 Oct 1831 d. 1926
9
Julia Wilmot
[1.1.6.14.1.5.1.11.3]
b. 7 Mar 1833 d. Sep 1913
Crawford Mayne Maxwell
b. 30 Dec 1816 d. 27 Oct 1894
10
Ethel Maxwell
[1.1.6.14.1.5.1.11.3.1]
b. 10 Oct 1859 d. 13 Sep 1941
John McPhillamy
b. 15 Jun 1850 d. 18 Feb 1935
11
Rymer Eileen McPhillamy
[1.1.6.14.1.5.1.11.3.1.1]
b. 17 Apr 1884 d. 24 Jun 1964
Alan Wilmot Maxwell
b. 1 Apr 1883 d. 21 Oct 1953
12
Sheila Mary Maxwell
[1.1.6.14.1.5.1.11.3.1.1.1]
b. 1 Nov 1912 d. 15 Jul 1989
12
Ian Maxwell
[1.1.6.14.1.5.1.11.3.1.1.2]
b. 6 Mar 1914 d. 1941
12
Living
[1.1.6.14.1.5.1.11.3.1.1.3]
12
Living
[1.1.6.14.1.5.1.11.3.1.1.4]
12
Alan Peter Maxwell
[1.1.6.14.1.5.1.11.3.1.1.5]
b. 6 Jul 1921 d. 12 Feb 1987
12
Michael Mayne Maxwell
[1.1.6.14.1.5.1.11.3.1.1.6]
b. 6 Jul 1921 d. 10 Apr 1948 [
=>
]
11
Marjorie Ursula McPhillamy
[1.1.6.14.1.5.1.11.3.1.2]
b. 29 Mar 1886 d. 17 Sep 1965
+
Hugh Richard Scarlett Campbell
b. 1878 d. 1943
11
Ethel Allison McPhillamy
[1.1.6.14.1.5.1.11.3.1.3]
b. 30 Dec 1888 d. 6 Feb 1978
John Collings Taswell Glossop
b. 23 Oct 1871 d. 23 Dec 1934
12
Alison Ethel Mary Glossop
[1.1.6.14.1.5.1.11.3.1.3.1]
b. 24 Jan 1919 d. 5 May 1970
11
Norma Monica McPhillamy
[1.1.6.14.1.5.1.11.3.1.4]
b. 23 Jun 1893 d. 1893
11
John Maxwell McPhillamy
[1.1.6.14.1.5.1.11.3.1.5]
b. 6 Feb 1897 d. 16 Jun 1951
+
Beatrice Kelly
b. 1904 d. 1992
10
Crawford John Maxwell
[1.1.6.14.1.5.1.11.3.2]
b. 23 Sep 1851 d. 26 Jan 1926
Caroline Emily Worthy Giblin
b. 1 Jan 1848 d. 28 Jan 1930
11
Crawford Mayne Maxwell
[1.1.6.14.1.5.1.11.3.2.1]
b. 18 Sep 1881 d. 1 May 1961
Kate Wanostrocht Gatenby
b. 1880
12
Living
[1.1.6.14.1.5.1.11.3.2.1.1]
12
Christina Mayne Maxwell
[1.1.6.14.1.5.1.11.3.2.1.2]
b. 1930 d. 1960
11
Alan Wilmot Maxwell
[1.1.6.14.1.5.1.11.3.2.2]
b. 1 Apr 1883 d. 21 Oct 1953
Rymer Eileen McPhillamy
b. 17 Apr 1884 d. 24 Jun 1964
12
Sheila Mary Maxwell
[1.1.6.14.1.5.1.11.3.2.2.1]
b. 1 Nov 1912 d. 15 Jul 1989
12
Ian Maxwell
[1.1.6.14.1.5.1.11.3.2.2.2]
b. 6 Mar 1914 d. 1941
12
Living
[1.1.6.14.1.5.1.11.3.2.2.3]
12
Living
[1.1.6.14.1.5.1.11.3.2.2.4]
12
Alan Peter Maxwell
[1.1.6.14.1.5.1.11.3.2.2.5]
b. 6 Jul 1921 d. 12 Feb 1987
12
Michael Mayne Maxwell
[1.1.6.14.1.5.1.11.3.2.2.6]
b. 6 Jul 1921 d. 10 Apr 1948 [
=>
]
11
Kenneth Graeme Maxwell
[1.1.6.14.1.5.1.11.3.2.3]
b. 11 Nov 1884 d. 21 May 1965
+
Kathleen Mary Holmes
b. 1889 d. 1981
11
Maurice Maxwell
[1.1.6.14.1.5.1.11.3.2.4]
b. 8 May 1886 d. 11 Oct 1967
+
Eileen Ida Crowther
b. 1888 d. 1970
11
Arthur Mainwaring Maxwell
[1.1.6.14.1.5.1.11.3.2.5]
b. 8 Jun 1888 d. 17 Jun 1966
Marion Gray Wemyss Bridges
b. 19 Aug 1896 d. Jan 1970
12
Meg Maxwell
[1.1.6.14.1.5.1.11.3.2.5.1]
b. 5 Nov 1927 d. 8 Jan 2000
12
Crawford William Maxwell
[1.1.6.14.1.5.1.11.3.2.5.2]
b. 27 Sep 1929 d. 15 Apr 1992
11
Brigadier Duncan Struan Maxwell
[1.1.6.14.1.5.1.11.3.2.6]
b. 8 Jan 1892 d. 21 Dec 1969
+
Marion Wistie Sly
b. 30 Jun 1888 d. 25 Mar 1969
10
Mowbray Maxwell
[1.1.6.14.1.5.1.11.3.3]
b. 10 Feb 1853 d. 6 Jun 1871
10
Charles Mayne Maxwell
[1.1.6.14.1.5.1.11.3.4]
b. 24 Jul 1854 d. 30 Dec 1899
+
Rossie Milne Ritchie
b. 27 May 1852 d. 1926
10
Julia Mainwaring Maxwell
[1.1.6.14.1.5.1.11.3.5]
b. 22 Dec 1856 d. 10 Jan 1925
10
Maud Marion Maxwell
[1.1.6.14.1.5.1.11.3.6]
b. 10 Apr 1858 d. 13 Sep 1941
10
Rymer Jane Maxwell
[1.1.6.14.1.5.1.11.3.7]
b. 6 Apr 1862 d. 13 Sep 1958
10
Eustace Maxwell
[1.1.6.14.1.5.1.11.3.8]
b. 20 Jan 1864 d. 17 May 1939
10
Kenneth Maxwell
[1.1.6.14.1.5.1.11.3.9]
b. 23 Sep 1865 d. 18 Feb 1916
+
Harriet Fraser Munro
b. 1854 d. 1921
10
Isabella Maxwell
[1.1.6.14.1.5.1.11.3.10]
b. 18 Apr 1867 d. 8 Dec 1946
+
Hugh Armstrong
b. Abt 1859 d. Aft 1912
10
Raymond Maxwell
[1.1.6.14.1.5.1.11.3.11]
b. 22 Aug 1868 d. 16 Apr 1932
+
Edith R Bridger
b. Abt 1868
10
Marguerite Maxwell
[1.1.6.14.1.5.1.11.3.12]
b. 16 Jun 1870 d. 17 Feb 1871
10
Muriel Gertrude Maxwell
[1.1.6.14.1.5.1.11.3.13]
b. 24 Feb 1872 d. 1 May 1950
Wilfred Wanostrocht Giblin
b. 12 May 1872 d. Abt 1952
11
Thomas Giblin
[1.1.6.14.1.5.1.11.3.13.1]
b. 17 Jun 1903 d. 18 Mar 1979
11
Muriel Nancy Giblin
[1.1.6.14.1.5.1.11.3.13.2]
b. 21 Apr 1905
11
Betty Wanostrocht Giblin
[1.1.6.14.1.5.1.11.3.13.3]
b. 6 Dec 1909 d. 1 Nov 1996
10
Elsie Gwendoline Maxwell
[1.1.6.14.1.5.1.11.3.14]
b. 19 Sep 1873 d. 1957
10
Eric Wilmot Maxwell
[1.1.6.14.1.5.1.11.3.15]
b. 1 Aug 1875 d. 1957
9
Isabella Wilmot
[1.1.6.14.1.5.1.11.4]
b. 1834 bur. 1865
Thomas Henry Lempriere
c. 14 Dec 1825 d. 1917
10
Thomas Charles Chubb Lempriere
[1.1.6.14.1.5.1.11.4.1]
b. 1855 d. 1901
+
Anne Lalor
b. 1856 d. 1885
Emily Stutely
b. 1855 d. 1913
11
Ruby Nellie Lempriere
[1.1.6.14.1.5.1.11.4.1.1]
b. 1888 d. 1978
11
Sidney Charles Stutely Lempriere
[1.1.6.14.1.5.1.11.4.1.2]
b. 1890 d. 1951
Lila May Wilson
b. 1891 d. 21 Jul 1974
12
Ellen Florence Stutley Lempriere
[1.1.6.14.1.5.1.11.4.1.2.1]
b. 1911 d. 1981
12
Gladys May Lempriere
[1.1.6.14.1.5.1.11.4.1.2.2]
b. 22 Nov 1912 d. 15 Feb 1982
12
Hilda Emily Lempriere
[1.1.6.14.1.5.1.11.4.1.2.3]
b. 1914 d. 1970
12
Sydney Ronald Lempriere
[1.1.6.14.1.5.1.11.4.1.2.4]
b. 1917 d. 1 May 1987
12
Kenneth Royce Lempriere
[1.1.6.14.1.5.1.11.4.1.2.5]
b. 1 Apr 1919 d. 1 Jan 1986
12
Thomas Charles Lempriere
[1.1.6.14.1.5.1.11.4.1.2.6]
b. 3 Jan 1922 d. 24 Aug 1982
12
Beryl Lempriere
[1.1.6.14.1.5.1.11.4.1.2.7]
b. 1925 d. 1989
11
Florence Maude Lempriere
[1.1.6.14.1.5.1.11.4.1.3]
b. 1892 d. Nov 1974
11
Thomas Albert Charles Lempriere
[1.1.6.14.1.5.1.11.4.1.4]
b. 1893 d. 26 Apr 1960
11
Bertram Norman Lempriere
[1.1.6.14.1.5.1.11.4.1.5]
b. 1896 d. 15 Jul 1973
+
Ruby Hughes Tickner
b. 1891 d. 1971
11
Vera Isabella Lempriere
[1.1.6.14.1.5.1.11.4.1.6]
b. 1898 d. 15 Dec 1988
+
Stanley Basden Hill
b. 1897 d. 24 Jul 1989
10
Leila Frances Isabelle Lempriere
[1.1.6.14.1.5.1.11.4.2]
b. 5 Sep 1859 d. 1944
Charles Ernest Henry Swyer
b. 1860 d. 1912
11
Rita Leila Swyer
[1.1.6.14.1.5.1.11.4.2.1]
b. 14 Apr 1888 d. 5 Feb 1971
10
Everard William Lempriere
[1.1.6.14.1.5.1.11.4.3]
b. 1862 d. 1902
+
Elizabeth Hughes
b. Abt 1862
10
Isabella Lempriere
[1.1.6.14.1.5.1.11.4.4]
b. 11 Apr 1865 d. 1865
9
Mary Elizabeth Wilmot
[1.1.6.14.1.5.1.11.5]
b. 1838 d. 1925
John Moore
b. 1840 d. 1927
10
Kenneth Ruthven Wilmot Moore
[1.1.6.14.1.5.1.11.5.1]
b. 1881 d. 1952
Kathleen Alice Smythe
b. 1882 d. 1966
11
Derek Pax Ruthven Moore
[1.1.6.14.1.5.1.11.5.1.1]
b. 1918 d. 1995
+
Scott
9
Charles Henry Austin Wilmot
[1.1.6.14.1.5.1.11.6]
b. 1842 d. 1859
8
Isabella Watson Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.12]
b. 9 Jan 1807 d. 1856
+
George John Scott
b. 1809 d. 1871
8
Juliana Eliza Elliston
[1.1.6.14.1.5.1.13]
b. 3 Nov 1810 d. 1850
George Philip Reinagle
b. 26 Dec 1804 d. 1835
9
Emily Catherine Reinagle
[1.1.6.14.1.5.1.13.1]
b. 1835 d. 8 Dec 1908
Frederick Bedwell
c. 26 Mar 1837 d. 7 Jun 1911
10
Arthur Lumley Bedwell
[1.1.6.14.1.5.1.13.1.1]
c. 1 Jul 1864 d. 15 Mar 1931
10
Frederick Arden Bedwell
[1.1.6.14.1.5.1.13.1.2]
b. Oct 1865 d. Mar 1889
10
Charles Wilmot Bedwell
[1.1.6.14.1.5.1.13.1.3]
c. 25 Dec 1866 d. 19 Mar 1935
Brenda Jannette Platt
b. 1880 d. 1935
11
Elizabeth Florence Oriana Bedwell
[1.1.6.14.1.5.1.13.1.3.1]
b. 1907 d. 1991
Richard Bertram
b. 1908 d. 1995
12
Living
[1.1.6.14.1.5.1.13.1.3.1.1]
10
Walter Merry Reinagle Bedwell
[1.1.6.14.1.5.1.13.1.4]
b. Oct 1870 d. 3 Sep 1933
+
Charles Howard
b. 1819 d. 1909
Caroline Fry
8
William Edward Fry
[1.1.6.14.1.5.1.14]
b. 1825 d. 1825
7
Frances Elliston
[1.1.6.14.1.5.2]
b. 1787
6
Thomas Elliston
[1.1.6.14.1.6]
6
Charles Edward Elliston
[1.1.6.14.1.7]
6
Elizabeth Elliston
[1.1.6.14.1.8]
d. 1853
Edward Ellis
d. 1777
7
Elizabeth Ellis
[1.1.6.14.1.8.1]
+
Mark Farley Wade
7
Edward Ellis
[1.1.6.14.1.8.2]
b. 1772 d. 1773
+
William Harrington
6
Abel Elliston
[1.1.6.14.1.9]
c. 10 Sep 1734
5
Thomas Elliston
[1.1.6.14.2]
b. Abt 1710
Thomasin Nice
6
Nice Elliston
[1.1.6.14.2.1]
b. Abt 1718
Sarah Alderton
b. Abt 1718
7
Nice Elliston
[1.1.6.14.2.1.1]
b. Abt 1739 d. 20 Nov 1820
Jane Selsby
c. 27 Feb 1737/1738 bur. 24 Mar 1775
8
Thomas Elliston
[1.1.6.14.2.1.1.1]
b. Abt 1770
Mary Green
b. Abt 1770
9
Thomas Elliston
[1.1.6.14.2.1.1.1.1]
c. 4 Mar 1792
Mary Mulley
b. Abt 1792
10
Thomas Elliston
[1.1.6.14.2.1.1.1.1.1]
b. Abt 1812
Rebecca Wright
b. Abt 1812
11
Frederick Thomas Elliston
[1.1.6.14.2.1.1.1.1.1.1]
b. Abt 1830
Elizabeth Berridge
b. Abt 1835
12
Herbert Berridge Elliston
[1.1.6.14.2.1.1.1.1.1.1.1]
b. 1895 d. 1957
Sarah Malkin
c. 14 Jul 1748 d. 18 Dec 1818
8
Sarah Sophia Elliston
[1.1.6.14.2.1.1.2]
c. 29 May 1780 d. 18 Sep 1817
8
Mary Ann Elliston
[1.1.6.14.2.1.1.3]
c. 19 Feb 1786 d. 4 Jun 1802
4
Sarah Elliston
[1.1.6.15]
c. 2 Mar 1682
4
Ann Elliston
[1.1.6.16]
c. 13 Mar 1683
4
John Elliston
[1.1.6.17]
c. 29 Mar 1686
4
Elizabeth Elliston
[1.1.6.18]
c. 20 Aug 1689
4
Joseph Elliston
[1.1.6.19]
c. 2 Feb 1690
4
Susan Elliston
[1.1.6.20]
c. 2 May 1692
4
William Elliston
[1.1.6.21]
c. 3 Oct 1693
4
Benjamin Elliston
[1.1.6.22]
c. 9 Jul 1695