Home Page
|
What's New
|
Photos
|
Histories
|
Headstones
|
Reports
|
Surnames
Search
First Name:
Last Name:
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Suomalainen
Svenska
Lydia Huckstep
1587 - 1672 (85 years)
Submit Photo / Document
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Submit Photo / Doc
Worksheet
Family
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Lydia Huckstep
[1]
b. 11 Feb 1587 d. 31 Jul 1672
Nathaniel Tilden
b. 28 Jul 1583 d. 25 May 1641
2
Elizabeth Ann Tilden
[1.1]
b. Abt 1603 d. Abt 1667
William Bassett
b. Abt 1590 d. 4 Apr 1667
3
William Bassett, Jr
[1.1.1]
b. Abt 1624 d. 29 May 1670
3
Elizabeth Bassett
[1.1.2]
b. Abt 1626 d. 5 Nov 1688
3
Sarah Bassett
[1.1.3]
b. Abt 1628 d. 22 Jan 1711
Peregrine White
b. Nov 1620 d. 20 Jul 1704
4
Daniel White
[1.1.3.1]
b. Abt 1649 d. 6 May 1724
Hannah Ann Hunt
b. 14 Feb 1640 d. 25 May 1721
5
Joseph White
[1.1.3.1.1]
b. 17 Dec 1662 d. 28 Oct 1757
Susanna Sherman
b. Abt 1678 d. 22 Dec 1766
6
Hannah White
[1.1.3.1.1.1]
b. 28 Mar 1702 d. 29 Jul 1775
6
Abijah White
[1.1.3.1.1.2]
b. 8 Oct 1706 d. 20 Oct 1775
Anna Little
b. 30 Jan 1715 d. 11 Mar 1791
7
Anna White
[1.1.3.1.1.2.1]
b. 1739 d. Bef 1829
7
Persilla White
[1.1.3.1.1.2.2]
b. 1740 d. Bef 1830
7
Sylvanus White
[1.1.3.1.1.2.3]
b. 1742
7
Abijah White
[1.1.3.1.1.2.4]
b. 1745 d. 8 Feb 1746
7
Deborah White
[1.1.3.1.1.2.5]
b. 20 Aug 1746 d. 19 Oct 1746
7
Abijah White
[1.1.3.1.1.2.6]
b. 1747 d. 1777
7
Sarah White
[1.1.3.1.1.2.7]
b. 29 Mar 1749 d. Bef 1839
7
William White
[1.1.3.1.1.2.8]
b. Abt 1752 d. 19 Dec 1817
7
John White
[1.1.3.1.1.2.9]
b. 9 Sep 1753 d. 1 Feb 1774
7
Susanna White
[1.1.3.1.1.2.10]
b. 1756 d. 10 Apr 1793
7
Anna White
[1.1.3.1.1.2.11]
b. 27 Oct 1759
7
Persilla White
[1.1.3.1.1.2.12]
b. 17 Oct 1760
6
Cornelius White
[1.1.3.1.1.3]
b. 29 Jan 1711 d. 8 Nov 1800
Hannah Riggs
b. Abt 1670 d. Aft 1752
7
Prudence White
[1.1.3.1.1.3.1]
b. Abt 1741
7
Mose White
[1.1.3.1.1.3.2]
b. 2 Aug 1743 d. 6 Mar 1829
7
Sarah White
[1.1.3.1.1.3.3]
b. Abt 1748 d. Bef 1848
7
Mary White
[1.1.3.1.1.3.4]
b. Abt 1749 d. 10 Mar 1838
7
Hannah White
[1.1.3.1.1.3.5]
b. 1 Jan 1750
7
Asa White
[1.1.3.1.1.3.6]
b. 4 Aug 1752 d. 17 Jan 1822
6
Sarah White
[1.1.3.1.1.4]
b. 31 May 1710 d. 15 Feb 1788
Isaac Phillips
b. 5 Mar 1701 d. 18 Sep 1787
7
Isaac Phillips, Jr
[1.1.3.1.1.4.1]
b. 16 Dec 1728 d. 11 Jun 1831
7
David Phillips
[1.1.3.1.1.4.2]
b. 17 Aug 1731
7
Sarah Phillips
[1.1.3.1.1.4.3]
b. 4 Apr 1735 d. 26 Jul 1760
7
Anna Phillips
[1.1.3.1.1.4.4]
b. 15 Mar 1736 d. 19 Jan 1819
7
James Phillips
[1.1.3.1.1.4.5]
b. 30 Mar 1739
7
Rebekah Phillips
[1.1.3.1.1.4.6]
b. 21 Mar 1742
7
Joseph Phillips
[1.1.3.1.1.4.7]
b. 1 Dec 1749 d. 1751
7
Solomon Phillips
[1.1.3.1.1.4.8]
b. Dec 1750
6
Rebekah White
[1.1.3.1.1.5]
b. 17 Dec 1713 d. 1716
6
Sylvanus White
[1.1.3.1.1.6]
b. 24 Jul 1718 d. 19 Dec 1742
6
Jesse White
[1.1.3.1.1.7]
b. 7 Dec 1720 d. 1765
Catherina Charlotte Wilhelmina Subellina Warner
b. Abt 1720 d. Abt 1771
7
Sybelene White
[1.1.3.1.1.7.1]
b. 1744 d. May 1747
7
Sybelene White
[1.1.3.1.1.7.2]
b. 1748
7
Christiana White
[1.1.3.1.1.7.3]
b. 1750 d. 5 Aug 1818
Lydia Copeland
b. 27 Mar 1642 d. 8 May 1727
6
Mary White
[1.1.3.1.1.8]
b. 27 Feb 1682 d. 1701
6
Captain Joseph White
[1.1.3.1.1.9]
b. 19 Oct 1683 d. 15 Jun 1737
Prudence Smith
b. 19 Jul 1691 d. 5 Apr 1785
7
Joseph White
[1.1.3.1.1.9.1]
b. 22 Sep 1712 d. 12 Mar 1788
Judeth Clarke
b. 1711 d. 3 Feb 1794
8
Sarah White
[1.1.3.1.1.9.1.1]
b. 1735 d. 1747
8
Tryal White
[1.1.3.1.1.9.1.2]
b. 8 May 1737 d. 14 Jun 1814
Lieutenant Abner Taft
b. 28 Dec 1736 d. 30 May 1809
9
Oliver Taft
[1.1.3.1.1.9.1.2.1]
b. 1 May 1758 d. 16 Jul 1775
9
Moses Taft
[1.1.3.1.1.9.1.2.2]
b. 29 Sep 1760 d. 4 Dec 1848
Judith Cummings
b. 26 Nov 1766 d. 26 Nov 1816
10
Nancy Taft
[1.1.3.1.1.9.1.2.2.1]
b. 10 Mar 1787
10
Samuel Taft
[1.1.3.1.1.9.1.2.2.2]
b. 24 Sep 1790 d. 11 Oct 1863
10
Lucy Taft
[1.1.3.1.1.9.1.2.2.3]
b. 24 Apr 1795 d. 21 Jun 1847
10
Newell Taft
[1.1.3.1.1.9.1.2.2.4]
b. 28 Jul 1804 d. 4 Nov 1873
Hannah G Taft
b. 18 May 1802 d. 8 Jan 1843
11
Albert Taft
[1.1.3.1.1.9.1.2.2.4.1]
b. 28 Aug 1823 d. Aft 1874
Sally L Bartlett
b. 14 Oct 1827 d. 1 Sep 1874
12
Charles B Taft
[1.1.3.1.1.9.1.2.2.4.1.1]
b. Feb 1854 d. 23 Sep 1854
12
Hannah L Taft
[1.1.3.1.1.9.1.2.2.4.1.2]
b. 5 Feb 1856
11
Marcy Taft
[1.1.3.1.1.9.1.2.2.4.2]
b. Mar 1829 d. 12 Apr 1830
11
Charles M Taft
[1.1.3.1.1.9.1.2.2.4.3]
b. Jan 1843 d. 7 Dec 1843
10
Sylvia Taft
[1.1.3.1.1.9.1.2.2.5]
b. 23 Aug 1810 d. 3 Aug 1816
9
Mary Taft
[1.1.3.1.1.9.1.2.3]
b. 12 Oct 1767 d. 18 Aug 1775
9
Webb Taft
[1.1.3.1.1.9.1.2.4]
b. 26 Mar 1772 d. 21 Apr 1842
Lucy Taft
b. 9 Jun 1774 d. 14 Mar 1846
10
Lucinda Taft
[1.1.3.1.1.9.1.2.4.1]
b. 22 Nov 1793
10
Jason Taft
[1.1.3.1.1.9.1.2.4.2]
b. 5 Jun 1796 d. 25 Oct 1861
9
Trial T Taft
[1.1.3.1.1.9.1.2.5]
b. 13 Apr 1777 d. 18 Aug 1815
8
Lois White
[1.1.3.1.1.9.1.3]
b. 25 Aug 1739 d. 7 Jan 1806
Edward Seagrave
b. Abt 1722 d. 20 May 1793
9
John Seagrave
[1.1.3.1.1.9.1.3.1]
b. 6 Nov 1757 d. 3 Feb 1842
9
Lois Seagrave
[1.1.3.1.1.9.1.3.2]
b. 5 Nov 1759 d. 8 Mar 1819
9
Sarah Sally Seagrave
[1.1.3.1.1.9.1.3.3]
b. 31 Dec 1760 d. 12 May 1851
9
Joseph Seagrave
[1.1.3.1.1.9.1.3.4]
b. 21 Dec 1761 d. 30 Aug 1830
9
Mary Seagrave
[1.1.3.1.1.9.1.3.5]
b. 1 Apr 1764 d. 1777
9
Bezaleel Seagrave
[1.1.3.1.1.9.1.3.6]
b. 14 Dec 1766 d. 1 Aug 1830
9
Caleb Seagrave
[1.1.3.1.1.9.1.3.7]
b. 14 Mar 1771 d. 22 Sep 1836
9
Josiah Seagrave
[1.1.3.1.1.9.1.3.8]
b. 14 Oct 1773 d. 20 Mar 1855
Lois Taft
b. 27 Aug 1780 d. 27 Apr 1854
10
Mary Ann Seagrave
[1.1.3.1.1.9.1.3.8.1]
b. 17 Nov 1799 d. 10 Feb 1825
10
Jacob Taft Seagraves
[1.1.3.1.1.9.1.3.8.2]
b. 8 Apr 1802 d. 24 Sep 1870
10
Henrietta Frost Seagrave
[1.1.3.1.1.9.1.3.8.3]
b. 1 Dec 1803 d. 1 Jun 1823
10
Waity Grant Seagrave
[1.1.3.1.1.9.1.3.8.4]
b. 23 Sep 1805 d. 27 Jan 1859
10
Edward Seagrave
[1.1.3.1.1.9.1.3.8.5]
b. 3 Sep 1807 d. 15 Feb 1873
10
Lois Taft Seagrave
[1.1.3.1.1.9.1.3.8.6]
b. 13 Apr 1809 d. 19 Mar 1853
10
Josiah Seagrave, Jr
[1.1.3.1.1.9.1.3.8.7]
b. 24 May 1811 d. 21 Jul 1861
10
Malvina Seagrave
[1.1.3.1.1.9.1.3.8.8]
b. 2 Apr 1813 d. 16 Dec 1823
10
Caleb Seagrave
[1.1.3.1.1.9.1.3.8.9]
b. 8 Feb 1815 d. 14 Nov 1823
10
Son Seagrave
[1.1.3.1.1.9.1.3.8.10]
b. 3 May 1817 d. 3 May 1817
10
Daughter Seagrave
[1.1.3.1.1.9.1.3.8.11]
b. 3 May 1817 d. 3 May 1817
10
Esborn Seagrave
[1.1.3.1.1.9.1.3.8.12]
b. 28 Dec 1818 d. 27 Oct 1856
10
George Augustus Seagrave
[1.1.3.1.1.9.1.3.8.13]
b. 6 Jan 1823 d. 15 Nov 1884
9
Edward Seagrave
[1.1.3.1.1.9.1.3.9]
b. 14 Oct 1773 d. 31 Jul 1797
9
Olive Seagrave
[1.1.3.1.1.9.1.3.10]
b. 17 Apr 1779 d. 1868
9
Samuel Seagraves
[1.1.3.1.1.9.1.3.11]
b. 3 Feb 1782 d. 4 Feb 1855
8
Joseph White
[1.1.3.1.1.9.1.4]
b. 1744 d. 1747
8
Judith White
[1.1.3.1.1.9.1.5]
b. 1746 d. 1747
8
Amos White
[1.1.3.1.1.9.1.6]
b. 1748 d. 1782
8
Joel White
[1.1.3.1.1.9.1.7]
b. 1751 d. 1835
8
Jesse White
[1.1.3.1.1.9.1.8]
b. 1754 d. 1830
8
Edward White
[1.1.3.1.1.9.1.9]
b. 1756 d. 1756
8
Abner White
[1.1.3.1.1.9.1.10]
b. 1758 d. 1758
8
Moses White
[1.1.3.1.1.9.1.11]
b. 1759 d. 1759
8
Eunice White
[1.1.3.1.1.9.1.12]
b. 1 Nov 1741 d. 3 Apr 1825
7
Peter White
[1.1.3.1.1.9.2]
b. 6 Dec 1714 d. 8 May 1782
Jemima Taft
b. 1 Apr 1713 d. 14 Oct 1787
8
Joseph White
[1.1.3.1.1.9.2.1]
b. 25 Jun 1738 d. 1805
8
Bethaih White
[1.1.3.1.1.9.2.2]
b. 1 Mar 1740 d. 1809
8
Elisabeth White
[1.1.3.1.1.9.2.3]
b. 13 Dec 1743
8
Peter White
[1.1.3.1.1.9.2.4]
b. 1746 d. 2 Dec 1821
8
Jemima White
[1.1.3.1.1.9.2.5]
b. Abt 1754 d. Abt 1782
8
Nathan White
[1.1.3.1.1.9.2.6]
b. 10 Jan 1755 d. 21 Jan 1828
7
Aaron White
[1.1.3.1.1.9.3]
b. 22 May 1717 d. Abt 1760
+
Susanah Benson
b. 2 Aug 1721 d. Aft 1750
7
Moses White
[1.1.3.1.1.9.4]
b. 31 Aug 1721
Abigail Holbrook
b. Abt 1721 d. 1787
8
Stephen White
[1.1.3.1.1.9.4.1]
b. 22 Sep 1754
8
Moses White
[1.1.3.1.1.9.4.2]
b. 24 Jul 1751
8
Abner White
[1.1.3.1.1.9.4.3]
b. 27 May 1753
7
Abigail White
[1.1.3.1.1.9.5]
b. 27 Jan 1723 d. 4 May 1751
Benoni Benson
b. 18 Jul 1724 d. 10 Jan 1806
8
Stephen Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1]
b. 15 Jul 1742 d. 30 Jul 1823
Mary Holbrook
b. 15 Jul 1745 d. 1849
9
Ichabod Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.1]
b. 30 Dec 1764 d. Aug 1794
Polly Herrick
b. 16 Aug 1763 d. 4 Oct 1847
10
Alonzo Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.1.1]
b. 6 Jan 1794 d. 4 Jun 1881
Abigail Johnston
b. 30 Aug 1795 d. 29 Feb 1880
11
Eliza Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.1.1.1]
b. 10 Nov 1820 d. 11 Oct 1846
Franklin Olney
b. 14 May 1817
12
Eliza Jeffords Olney
[1.1.3.1.1.9.5.1.1.1.1.1]
b. 30 Jul 1846 d. 5 Nov 1912
11
Alma Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.1.1.2]
b. 10 Sep 1821 d. 22 Jun 1921
William Moore
b. Abt 1819
12
Charles Moore
[1.1.3.1.1.9.5.1.1.1.2.1]
b. 1849
12
George L Moore
[1.1.3.1.1.9.5.1.1.1.2.2]
b. 1857
11
Lyman Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.1.1.3]
b. 10 Dec 1822 d. 18 Feb 1917
Mariatte Gibson
b. 13 Sep 1824 d. 24 Jul 1895
12
Henry E Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.1.1.3.1]
b. 1847
11
Ichabod Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.1.1.4]
b. 19 Dec 1823 d. 22 Sep 1901
+
Mary J Lord
b. 1834
11
Alonzo Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.1.1.5]
b. 2 May 1826 d. 16 Nov 1876
+
Rhoda Eaton
b. 19 Jan 1824 d. 27 Jul 1894
11
Son Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.1.1.6]
b. 14 Jun 1827 d. 28 Jul 1827
11
Harvey Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.1.1.7]
b. 14 Jul 1828 d. 3 Jun 1864
11
Gaylord S Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.1.1.8]
b. 28 Sep 1829 d. 18 Jul 1918
+
Huldah Celinda Cronkhite
b. 20 Mar 1844 d. 23 Mar 1932
11
Abbie J Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.1.1.9]
b. 22 Jan 1831
11
Lavantia E Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.1.1.10]
b. 4 Oct 1832
Charles H Johnston
b. 15 Jan 1838
12
Freddy E Johnston
[1.1.3.1.1.9.5.1.1.1.10.1]
b. 20 Mar 1861 d. 3 Jan 1863
12
Valencourt Johnston
[1.1.3.1.1.9.5.1.1.1.10.2]
b. 23 Apr 1862
12
Kirk Johnston
[1.1.3.1.1.9.5.1.1.1.10.3]
b. 25 Nov 1866
12
Florence Elizabeth Johnston
[1.1.3.1.1.9.5.1.1.1.10.4]
b. 1867 d. 3 Feb 1942 [
=>
]
11
Orson Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.1.1.11]
b. 18 Mar 1835 d. 30 Nov 1859
11
Mary Louise Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.1.1.12]
b. 7 Sep 1837 d. 12 Aug 1870
Lysander Hill
b. 3 Nov 1832 d. 1896
12
Willis G Hill
[1.1.3.1.1.9.5.1.1.1.12.1]
b. 22 Jul 1864 d. 11 May 1931 [
=>
]
12
Wallace A Hill
[1.1.3.1.1.9.5.1.1.1.12.2]
b. 22 Jul 1864 d. 1898 [
=>
]
12
Maude L Hill
[1.1.3.1.1.9.5.1.1.1.12.3]
b. Abt 1871 d. 9 Feb 1875
9
Elkanah Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2]
b. 21 Feb 1766 d. 8 Mar 1844
Deobrah Wheelock
b. 17 Dec 1765 d. 3 Aug 1846
10
Samuel Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.1]
b. 21 May 1791
Mary Van Liew
b. 8 Jul 1797 d. 22 Apr 1859
11
William Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.1.1]
b. 18 Dec 1817
11
Emily Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.1.2]
b. 18 Dec 1817
+
George Van Heusen
b. 3 Jun 1816 d. 25 Mar 1872
11
Alzina Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.1.3]
b. 8 Nov 1819 d. 29 Mar 1867
+
Charles W Ingersoll
b. 1817
11
Augustus Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.1.4]
b. 10 Feb 1822
11
Phila Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.1.5]
b. 8 Mar 1824
William Jenkins
b. 1820 d. 14 May 1864
12
Walter Jenkins
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.1.5.1]
b. 1857 d. 14 May 1864
12
Emma Jenkins
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.1.5.2]
b. 1861
11
Nathan S Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.1.6]
b. 17 Sep 1826 d. 1869
Martha Mead
b. 1838
12
Cora Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.1.6.1]
b. Abt 1860
12
Florence E Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.1.6.2]
b. Feb 1862
12
Alice Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.1.6.3]
b. Abt 1864
12
Nellie Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.1.6.4]
b. Abt 1866
11
James Mapes Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.1.7]
b. 12 Jun 1828 d. 11 Oct 1907
Margaret Jane Williamson
b. 4 Dec 1834 d. 20 Feb 1905
12
Francis Coe Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.1.7.1]
b. 22 Feb 1860
12
James Clarence Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.1.7.2]
b. 24 May 1862 d. 12 Jul 1920 [
=>
]
11
Montgomery Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.1.8]
b. Abt 1833
11
Mary Ellen Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.1.9]
b. Abt 1839
+
Cyrus B Kinne
b. Jan 1835
10
Chloe Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.2]
b. 6 Jan 1793 d. 1882
Lewis Smith
b. Abt 1790
11
Mary Smith
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.2.1]
b. Abt 1813 d. 1913
+
Henry Gilman Darling
b. 16 Aug 1810 d. 17 Dec 1870
11
Sidney Smith
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.2.2]
b. 29 Jan 1815 d. 10 Sep 1900
Jennie Ann Calkins
b. 1835
12
Adelia Smith
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.2.2.1]
b. Apr 1866 [
=>
]
12
Anna Smith
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.2.2.2]
b. 1869
11
William Smith
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.2.3]
b. Abt 1817
11
Lewis Smith
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.2.4]
b. Abt 1820
11
Stephen Smith
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.2.5]
b. 19 Feb 1823 d. 26 Aug 1922
Lucy Colver
b. 13 Oct 1835 d. 12 Sep 1905
12
Florence Nightingale Smith
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.2.5.1]
b. 8 Nov 1861
12
Evangeline Smith
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.2.5.2]
b. Abt 1863 d. Abt 1868
12
Sidney Smith
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.2.5.3]
b. 23 Dec 1864
12
Caroline Smith
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.2.5.4]
b. 4 Aug 1866 d. 11 Mar 1868
12
Stephen Smith
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.2.5.5]
b. 27 Dec 1868 d. 8 Jan 1889
12
Evalyn C Smith
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.2.5.6]
b. 28 Dec 1868
12
Lucille Carroll Smith
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.2.5.7]
b. 30 Jan 1873
12
Dean Smith
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.2.5.8]
b. 28 Aug 1875
12
Anna Jaffray Smith
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.2.5.9]
b. 8 Jun 1878
11
Job Lewis Smith
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.2.6]
b. 15 Oct 1827 d. 9 Jun 1897
10
Adolphus Willard Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.3]
b. 17 Dec 1795 d. 18 May 1878
Hannah Vermilyea
b. 1796 d. 28 Jun 1886
11
Edward Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.3.1]
b. 1824
11
Bryon L Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.3.2]
b. 25 Dec 1825 d. 23 Oct 1912
Angelina Howard
b. 16 Jul 1836 d. 24 Nov 1922
12
Alice Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.3.2.1]
b. 15 Aug 1858 d. 19 May 1879
11
Lewis Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.3.3]
b. Abt 1827
11
Elizabeth Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.3.4]
b. Abt 1829
11
Ellen Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.3.5]
b. Abt 1831
11
John Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.3.6]
b. Abt 1833
11
Henry Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.3.7]
b. Abt 1835
11
Jane H Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.3.8]
b. Abt 1837
11
Frank Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.3.9]
b. Abt 1839
10
Eliza Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.4]
b. 9 Mar 1798 d. 13 Nov 1817
+
James Miller
b. Abt 1795
10
Leonard Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.5]
b. 7 Apr 1800 d. 7 Sep 1877
Ruth Ann Reynolds
b. 23 Jul 1805 d. 2 Feb 1853
11
Elisha Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.5.1]
b. 1829
Helen R Sherman
b. 1839
12
Hattie Isabel Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.5.1.1]
b. Abt 1860
12
Carrie A Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.5.1.2]
b. 4 Dec 1861 d. 1 Jul 1949 [
=>
]
12
Ida May Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.5.1.3]
d. Bef 1908
11
William R Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.5.2]
b. 1831 d. 26 Feb 1889
Lucy Ann Clark
b. 16 Dec 1836 d. 21 Feb 1903
12
Edith Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.5.2.1]
b. 1868
12
Melvin Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.5.2.2]
b. 1869 d. 1870
12
Eva L Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.5.2.3]
b. Mar 1875
11
John Thompson Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.5.3]
b. 25 May 1833 d. 2 Apr 1914
Louisa Clark
b. 18 Nov 1835 d. 23 Jan 1918
12
Jay Clark Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.5.3.1]
b. Aug 1856 d. 26 Aug 1937 [
=>
]
12
Leonard E Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.5.3.2]
b. Jun 1860 d. 3 Jan 1927
11
Emory J Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.5.4]
b. Jul 1836 d. 8 Mar 1926
Jane Ann Van Sickle
b. 20 Mar 1838
12
Ella L Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.5.4.1]
b. Abt 1863
12
Clarence Emery Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.5.4.2]
b. Jan 1870 [
=>
]
12
Alma Edna Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.5.4.3]
b. May 1880
+
Helen Rebecca Sherman
11
Finley E Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.5.5]
b. Abt 1841
Maria Higby
b. Abt 1843 d. Bef 1910
12
Marion Arthur Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.5.5.1]
b. 13 Nov 1868 d. Aft 28 Apr 1930 [
=>
]
12
Delbert Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.5.5.2]
b. Abt 1878
Hannah Sherman
11
Mary Isabelle Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.5.6]
b. 7 Jun 1853 d. 9 Dec 1935
Howard Spurgeon Green
b. 25 Aug 1850 d. 24 Jan 1912
12
Roy C Green
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.5.6.1]
b. 3 Nov 1879 d. Jul 1955 [
=>
]
12
Leonard Benson Green
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.5.6.2]
b. 10 Nov 1882 d. 24 Jul 1947
12
Helen Ione Green
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.5.6.3]
b. 23 Oct 1893
10
Phila Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.6]
b. 27 Jul 1802
Charles Warner
b. Abt 1800
11
Susan Warner
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.6.1]
b. 1828
11
Mary Warner
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.6.2]
b. 1830
11
Harriet Warner
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.6.3]
b. 1832
10
Calista Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.7]
b. 2 Jun 1804 d. 15 Sep 1882
Jacob Conklin
b. 19 Sep 1798 d. 1 Nov 1884
11
Sarah Conklin
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.7.1]
b. 1828
11
Edward Conklin
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.7.2]
b. Abt 1828
11
Sory Ann Conklin
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.7.3]
b. 1831 d. 7 Feb 1832
11
Benson Conklin
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.7.4]
b. May 1833
Tina Ann Roseboone
b. 1838
12
Ella Mary Abbott Conklin
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.7.4.1]
b. 16 May 1856
12
Frank B Conklin
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.7.4.2]
b. 1857
12
Gilbert Conklin
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.7.4.3]
b. 1859
12
Charles Conklin
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.7.4.4]
b. 1860 d. 6 Sep 1865
12
Lizzie Conklin
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.7.4.5]
b. 1862
12
Kittie E Conklin
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.7.4.6]
b. 1872
+
Della J Walsh
b. Feb 1838
11
John Conklin
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.7.5]
b. 1835 d. 25 Oct 1835
11
Maria Conklin
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.7.6]
b. 1837 d. 1850
11
Daughter Conklin
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.7.7]
b. 1840 d. 1840
11
Eugene Conklin
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.7.8]
b. 1841 d. 14 Apr 1912
Harriet Ann Van Etten
b. 1845 d. 2 Jun 1932
12
Nellie V Conklin
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.7.8.1]
b. 1872 d. 16 Sep 1893
12
Mary F Conklin
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.7.8.2]
b. 1881 d. 25 Aug 1960
11
Daughter Conklin
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.7.9]
b. 1843 d. 3 Mar 1843
11
Lewis Smith Conklin
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.7.10]
b. Nov 1845 d. 28 Feb 1905
Persis Wiggins
b. May 1848 d. 4 May 1920
12
Florence Conklin
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.7.10.1]
b. 1877 bur. 14 Aug 1894
12
Anna Bessie Conklin
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.7.10.2]
b. Apr 1877
12
Don J Conklin
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.7.10.3]
b. Oct 1880
12
Sarah C Conklin
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.7.10.4]
b. Sep 1888
11
Annette Conklin
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.7.11]
b. 1848 d. 22 Jun 1848
10
Ruth Wheelock Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.8]
b. 21 Sep 1807
William J Vermilyea
b. 7 Jul 1803 d. 30 Jun 1879
11
Francis Arvilla Vermilyea
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.8.1]
b. 19 Apr 1830 d. 19 Nov 1915
Isaac Fuller Camp
b. 11 Feb 1823 d. 10 Aug 1890
12
Edwin L Camp
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.8.1.1]
b. 13 Mar 1851
12
Ida M Vermilyea
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.8.1.2]
b. 8 Mar 1857
12
Hanna Ruth Camp
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.8.1.3]
b. 23 Apr 1859
12
Albert E Camp
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.8.1.4]
b. Nov 1862
12
Mary A Camp
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.8.1.5]
b. 1864
12
William Whitney Camp
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.8.1.6]
b. 5 Feb 1867
11
Emily Benson Vermilyea
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.8.2]
b. 6 Dec 1831 d. Jun 1902
William Henry Myers
b. 1827
12
William Franklin Myers
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.8.2.1]
b. 1855
12
Selina Delphenie Myers
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.8.2.2]
b. 1857
12
Elizabeth Lorma Myers
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.8.2.3]
b. 1860
12
Henrietta Lorma Myers
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.8.2.4]
b. 1862
12
Harriet Benson Myers
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.8.2.5]
b. 1869
12
Gertrude Lucinia Myers
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.8.2.6]
b. 1874
11
Sidney Smith Vermilyea
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.8.3]
b. 27 Oct 1835 d. 22 Dec 1929
Amanda Fluke
b. 31 May 1842 d. 31 Mar 1937
12
Owen C Vermilyea
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.8.3.1]
b. 20 Jul 1864 d. 1919 [
=>
]
12
Henry Arthur Vermilyea
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.8.3.2]
b. 12 Mar 1867 [
=>
]
12
Bert Vermilyea
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.8.3.3]
b. 4 Dec 1868 [
=>
]
12
Charles E Vermilyea
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.8.3.4]
b. 15 Jan 1871 [
=>
]
12
Edgar L Vermilyea
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.8.3.5]
b. 12 Oct 1874 [
=>
]
12
Mary A Vermilyea
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.8.3.6]
b. 2 Feb 1880 d. Abt 1981
11
Elkanah Benson Vermilyea
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.8.4]
b. 9 Sep 1837 d. 31 May 1838
11
Chauncey Vermilyea
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.8.5]
b. 25 Mar 1839 d. 16 Jun 1863
11
Eliza Prudence Vermilyea
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.8.6]
b. 4 Apr 1842 d. 1923
James Tytler Johnstone
c. 18 Oct 1840 d. 1913
12
Harry Vermilyea Johnstone
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.8.6.1]
b. 1872
12
Elizabeth Winifred Johnstone
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.8.6.2]
b. 1873
12
James Charles Johnstone
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.8.6.3]
b. 1875
12
John Harvey Johnstone
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.8.6.4]
b. 1877
12
James Benson Johnstone
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.8.6.5]
b. 1880
12
Donald Denny Johnstone
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.8.6.6]
b. 1884
11
John Benson Vermilyea
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.8.7]
b. 26 May 1844
+
Mary Elizabeth Frizzle
b. 1848
11
Albert Gallatin Vermilyea
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.8.8]
b. 15 Sep 1846
Samantha Sophia Crawford
b. 1850
12
Lillie Alice Vermilyea
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.8.8.1]
b. 26 Sep 1872
12
Carl Crawford Vermilyea
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.8.8.2]
b. 1 Feb 1874 [
=>
]
12
Daughter Vermilyea
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.8.8.3]
b. 1877 d. 1877
10
Sarah Elizabeth Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.9]
b. 1 Jul 1809 d. 20 Jul 1888
Leicester Dodge
b. 28 Apr 1808 d. 5 Sep 1843
11
Ermina P Dodge
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.9.1]
b. 14 Feb 1831
+
Rufus Moe
11
Henry Benson Dodge
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.9.2]
b. 3 Oct 1832 d. 16 Feb 1914
Sally Betsey Howard
b. 27 Dec 1834 d. 15 Dec 1919
12
Emaline Elizabeth Dodge
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.9.2.1]
b. 29 Dec 1861 d. 1932
12
Ezra Leicester Dodge
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.9.2.2]
b. 22 Nov 1863 d. 3 Dec 1950
12
Benson Henry Dodge
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.9.2.3]
b. 15 Jan 1867 d. 25 Jun 1931 [
=>
]
12
Susan Louisa Dodge
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.9.2.4]
b. 28 May 1868 d. 8 Oct 1913
12
Hattie Blanche Dodge
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.9.2.5]
b. 25 Jun 1870 d. 1944 [
=>
]
11
Flora Elizabeth Dodge
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.9.3]
b. 6 Nov 1834
+
Horace Richards
11
Sarah Janette Dodge
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.9.4]
b. 20 Sep 1836
11
Calista Augusta Dodge
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.9.5]
b. 23 Nov 1838 d. 29 Aug 1884
+
William Alexander Gunsaullus
b. 15 Jul 1835 d. 27 Aug 1871
11
Caroline Emelia Dodge
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.9.6]
b. 30 Aug 1841 d. 7 Dec 1913
William Hadcill Carr
b. 13 Dec 1836 d. 19 Mar 1909
12
Florence A Carr
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.9.6.1]
b. 22 Jan 1864 d. 17 Feb 1904
12
Arthur Elmer Carr
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.9.6.2]
b. 19 Jun 1867 d. 20 Oct 1943
11
Lester Lewis Dodge
[1.1.3.1.1.9.5.1.2.9.7]
b. 30 Oct 1843
9
Esther Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.3]
b. 8 Dec 1768 d. 31 Mar 1855
Isaac Staples
b. 9 Mar 1742 d. 29 May 1848
10
Esther Staples
[1.1.3.1.1.9.5.1.3.1]
b. Abt 1790 d. 17 May 1878
10
Abraham Staples
[1.1.3.1.1.9.5.1.3.2]
b. 12 Mar 1792 d. 5 Sep 1881
10
Scammel Staples
[1.1.3.1.1.9.5.1.3.3]
b. 29 Dec 1798 d. 5 Apr 1883
10
Warren Staples
[1.1.3.1.1.9.5.1.3.4]
b. 17 Jan 1802
10
Evaline Staples
[1.1.3.1.1.9.5.1.3.5]
b. 11 Aug 1807 d. 2 Oct 1858
9
Ezekial Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.4]
b. 13 Mar 1770
9
Phila Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.5]
b. 23 Feb 1772
Phineas Tyler
b. 14 Feb 1765 d. 21 Jan 1847
10
Daniel Tyler
[1.1.3.1.1.9.5.1.5.1]
b. 2 Aug 1791
10
Phila Tyler
[1.1.3.1.1.9.5.1.5.2]
b. Abt 1793
10
Mary Tyler
[1.1.3.1.1.9.5.1.5.3]
b. 30 Mar 1794 d. 5 Aug 1885
Captain Henry Austin
b. 30 Jan 1782 d. 23 Jan 1852
11
Mary Austin
[1.1.3.1.1.9.5.1.5.3.1]
b. 2 Aug 1815 d. 1832
11
Emily Austin
[1.1.3.1.1.9.5.1.5.3.2]
b. 11 Nov 1817 d. 28 Jan 1860
11
Harriet Austin
[1.1.3.1.1.9.5.1.5.3.3]
b. 23 Nov 1819 d. 25 Feb 1858
11
Edward Taylor Austin
[1.1.3.1.1.9.5.1.5.3.4]
b. 26 Jul 1822
11
John Thompson Austin
[1.1.3.1.1.9.5.1.5.3.5]
b. 13 Jun 1824 d. 26 Dec 1842
9
Polly Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.6]
b. 7 Nov 1773
John Robinson
b. Abt 1769
10
Tryphenia Robinson
[1.1.3.1.1.9.5.1.6.1]
b. Abt 1795
10
Lydia Robinson
[1.1.3.1.1.9.5.1.6.2]
b. Abt 1797
10
Ezekial Robinson
[1.1.3.1.1.9.5.1.6.3]
b. Abt 1799
10
Hiram Robinson
[1.1.3.1.1.9.5.1.6.4]
b. Abt 1801
10
Andrew Robinson
[1.1.3.1.1.9.5.1.6.5]
b. Abt 1803
10
John Robinson
[1.1.3.1.1.9.5.1.6.6]
b. Abt 1805
10
Norman Robinson
[1.1.3.1.1.9.5.1.6.7]
b. Abt 1807
9
Sally Benson
[1.1.3.1.1.9.5.1.7]
b. 13 Feb 1776 d. 24 Nov 1837
Amos Boyden
b. 1766 d. 30 Apr 1836
10
Abigail Boyden
[1.1.3.1.1.9.5.1.7.1]
b. 6 Aug 1791
Allen Richardson
11
Sally Ann Richardson
[1.1.3.1.1.9.5.1.7.1.1]
b. 14 Jan 1816
11
Nancy L Richardson
[1.1.3.1.1.9.5.1.7.1.2]
b. 13 Apr 1818 d. 10 Jun 1895
Samuel F Freeman
b. 1822
12
Henry J Freeman
[1.1.3.1.1.9.5.1.7.1.2.1]
b. 1850 [
=>
]
12
Sarah H Freeman
[1.1.3.1.1.9.5.1.7.1.2.2]
b. 28 Feb 1852
12
William F Freeman
[1.1.3.1.1.9.5.1.7.1.2.3]
b. 1854 [
=>
]
12
Jennie E Freeman
[1.1.3.1.1.9.5.1.7.1.2.4]
b. 1856 d. 27 Mar 1899
12
Fanny J Freeman
[1.1.3.1.1.9.5.1.7.1.2.5]
b. 1856 [
=>
]
12
Herbert Stanley Freeman
[1.1.3.1.1.9.5.1.7.1.2.6]
b. 1859 [
=>
]
11
Isaac A Richardson
[1.1.3.1.1.9.5.1.7.1.3]
b. 26 Nov 1820
11
Susan Amy Richardson
[1.1.3.1.1.9.5.1.7.1.4]
b. 21 Feb 1823
11
Asenath T Richardson
[1.1.3.1.1.9.5.1.7.1.5]
b. 5 May 1825
11
Fanny J Richardson
[1.1.3.1.1.9.5.1.7.1.6]
b. 29 Nov 1827
11
Albert S Richardson
[1.1.3.1.1.9.5.1.7.1.7]
b. 18 Feb 1832 d. 8 Aug 1832
11
Allen Richardson
[1.1.3.1.1.9.5.1.7.1.8]
d. 29 Apr 1835
10
Aseneth Boyden
[1.1.3.1.1.9.5.1.7.2]
b. 10 Sep 1794 d. Apr 1886
+
Ellis Taft
b. 23 May 1796 d. 27 Aug 1851
10
David Boyden
[1.1.3.1.1.9.5.1.7.3]
b. 11 Mar 1797
10
Nancy Boyden
[1.1.3.1.1.9.5.1.7.4]
b. 23 Mar 1799
+
Salem Town
b. 1802
10
Sally Boyden
[1.1.3.1.1.9.5.1.7.5]
b. 3 Apr 1806 d. 13 Sep 1808
10
William Collins Boyden
[1.1.3.1.1.9.5.1.7.6]
b. 14 May 1801 d. 30 Nov 1803
10
Joel Boyden
[1.1.3.1.1.9.5.1.7.7]
b. 7 Jul 1803 d. 2 Aug 1835
Mary Andrews
b. 1808 d. 12 Mar 1829
11
Amos Boyden
[1.1.3.1.1.9.5.1.7.7.1]
b. 4 Aug 1827
Mary Amanda Boyden
b. 16 Aug 1834
12
Henry Pierce Boyden
[1.1.3.1.1.9.5.1.7.7.1.1]
b. 18 Sep 1862
12
Samuel Mowry Boyden
[1.1.3.1.1.9.5.1.7.7.1.2]
b. 8 Dec 1869
12
Son Boyden
[1.1.3.1.1.9.5.1.7.7.1.3]
b. 1 Jul 1871
12
Josiah S Boyden
[1.1.3.1.1.9.5.1.7.7.1.4]
b. 1875 d. 24 Mar 1875
+
Rebecca Stearns
b. 1797 d. Apr 1833
10
Amy Smith Boyden
[1.1.3.1.1.9.5.1.7.8]
b. 10 Jul 1808 d. 31 Jul 1838
10
William Collins Boyden
[1.1.3.1.1.9.5.1.7.9]
b. 8 May 1811
Emily M Mowry
b. 13 Oct 1814 d. 25 May 1880
11
Mary Amanda Boyden
[1.1.3.1.1.9.5.1.7.9.1]
b. 16 Aug 1834
Amos Boyden
b. 4 Aug 1827
12
Henry Pierce Boyden
[1.1.3.1.1.9.5.1.7.9.1.1]
b. 18 Sep 1862
12
Samuel Mowry Boyden
[1.1.3.1.1.9.5.1.7.9.1.2]
b. 8 Dec 1869
12
Son Boyden
[1.1.3.1.1.9.5.1.7.9.1.3]
b. 1 Jul 1871
12
Josiah S Boyden
[1.1.3.1.1.9.5.1.7.9.1.4]
b. 1875 d. 24 Mar 1875
11
William Collins Boyden
[1.1.3.1.1.9.5.1.7.9.2]
b. 3 Apr 1836 d. 20 Mar 1882
11
Sanford H Boyden
[1.1.3.1.1.9.5.1.7.9.3]
b. 20 Dec 1838 d. 18 Sep 1869
11
Decatur M Boyden
[1.1.3.1.1.9.5.1.7.9.4]
b. 21 Aug 1840 d. Abt 1951
Frances L Poland
b. 1845 d. Bef 1955
12
Edith Louise Boyden
[1.1.3.1.1.9.5.1.7.9.4.1]
b. 2 Aug 1863 d. Bef 1979
12
Osborn Decatur Boyden
[1.1.3.1.1.9.5.1.7.9.4.2]
b. 15 Jul 1866
12
Grace Lemond Boyden
[1.1.3.1.1.9.5.1.7.9.4.3]
b. 10 Sep 1872
11
Emily Frances Boyden
[1.1.3.1.1.9.5.1.7.9.5]
b. 19 Jan 1845 d. 17 Sep 1846
11
Emily Ann Boyden
[1.1.3.1.1.9.5.1.7.9.6]
b. 10 Jan 1848 d. Abt 1958
11
Reuben M Boyden
[1.1.3.1.1.9.5.1.7.9.7]
b. 19 Dec 1853 d. 5 Sep 1887
11
Amey Boyden
[1.1.3.1.1.9.5.1.7.9.8]
b. 23 May 1856 d. 30 Sep 1915
8
Henry Benson
[1.1.3.1.1.9.5.2]
b. 5 Dec 1743 d. 7 Dec 1777
Susanna Thayer
b. 23 Apr 1746 d. 4 Jan 1808
9
Hannah Benson
[1.1.3.1.1.9.5.2.1]
b. 7 May 1764
+
Aaron Legg
9
Joanna Benson
[1.1.3.1.1.9.5.2.2]
b. 6 Jul 1766 d. 29 Dec 1820
Daniel Holbrook
b. 7 Feb 1765 d. 10 Jun 1831
10
Henry Benson Holbrook
[1.1.3.1.1.9.5.2.2.1]
b. 21 Aug 1788 d. 1870
Rebecca Austin
b. 27 Oct 1796
11
Isaac Holbrook
[1.1.3.1.1.9.5.2.2.1.1]
b. 7 Nov 1816 d. 19 Apr 1875
11
Betsy Holbrook
[1.1.3.1.1.9.5.2.2.1.2]
b. 1821 d. 6 Dec 1897
11
Francis M Holbrook
[1.1.3.1.1.9.5.2.2.1.3]
b. 20 Jul 1823 d. 7 May 1906
Arlina M Raymond
b. 4 Apr 1831 d. 1903
12
Byron D Holbrook
[1.1.3.1.1.9.5.2.2.1.3.1]
b. 15 Oct 1847 d. 26 Jan 1848
12
Mary Eugenia Holbrook
[1.1.3.1.1.9.5.2.2.1.3.2]
b. 10 Jan 1850 d. 29 Aug 1875 [
=>
]
12
Fanny Maria Holbrook
[1.1.3.1.1.9.5.2.2.1.3.3]
b. 19 Dec 1853 d. 1881 [
=>
]
12
Henry B Holbrook
[1.1.3.1.1.9.5.2.2.1.3.4]
b. 24 Jan 1856 d. 9 Sep 1862
12
James R Holbrook
[1.1.3.1.1.9.5.2.2.1.3.5]
b. 19 Mar 1861 d. 9 Apr 1862
12
Bertha Arlina Holbrook
[1.1.3.1.1.9.5.2.2.1.3.6]
b. 24 Jan 1865
11
Charles Holbrook
[1.1.3.1.1.9.5.2.2.1.4]
b. 1834
10
Marcus Holbrook
[1.1.3.1.1.9.5.2.2.2]
b. Abt 1791 d. Aft 1840
+
Abigail Wild
10
Lydia Holbrook
[1.1.3.1.1.9.5.2.2.3]
b. Abt 1793 d. 19 Feb 1820
10
Daniel Holbrook
[1.1.3.1.1.9.5.2.2.4]
b. 28 Feb 1796 d. 18 Oct 1864
10
Rufus Holbrook
[1.1.3.1.1.9.5.2.2.5]
b. Abt 1801
Mary Wyman
b. 1801
11
Atward D Holbrook
[1.1.3.1.1.9.5.2.2.5.1]
b. 1831 d. 1900
Harriet Crehore
b. 3 Feb 1831 d. 4 Jan 1910
12
Hattie L Holbrook
[1.1.3.1.1.9.5.2.2.5.1.1]
b. 1857 d. 1860
10
Abraham Staples Holbrook
[1.1.3.1.1.9.5.2.2.6]
b. Abt 1806 d. 1 May 1862
+
Sally Dearborn
b. 22 Jun 1807 d. 20 Mar 1863
10
Millins Holbrook
[1.1.3.1.1.9.5.2.2.7]
b. Abt 1808
Laura Temple
b. 5 May 1808 d. 12 Sep 1864
11
Harriet Elizabeth Holbrook
[1.1.3.1.1.9.5.2.2.7.1]
b. 14 Jan 1835
Levi W Wellington
b. Oct 1829
12
Lillian Wellington
[1.1.3.1.1.9.5.2.2.7.1.1]
b. Abt 1856 [
=>
]
12
Frank L Wellington
[1.1.3.1.1.9.5.2.2.7.1.2]
b. Abt 1857 [
=>
]
12
Carlton G Wellington
[1.1.3.1.1.9.5.2.2.7.1.3]
b. 12 Nov 1859 d. 12 Jul 1937 [
=>
]
12
Ivan R Wellington
[1.1.3.1.1.9.5.2.2.7.1.4]
b. Sep 1879
11
Daniel Henry Holbrook
[1.1.3.1.1.9.5.2.2.7.2]
b. 9 Feb 1841
11
Fanny Maria Holbrook
[1.1.3.1.1.9.5.2.2.7.3]
b. 24 Dec 1841
11
George Benson Holbrook
[1.1.3.1.1.9.5.2.2.7.4]
b. Sep 1846 d. 4 Jul 1922
Ellen Beebe
b. 1852
12
George Millins Holbrook
[1.1.3.1.1.9.5.2.2.7.4.1]
b. 27 Jan 1870 d. 21 Feb 1935 [
=>
]
12
Emma L Holbrook
[1.1.3.1.1.9.5.2.2.7.4.2]
b. 17 Oct 1871 d. 15 Apr 1966
12
Elinor B Holbrook
[1.1.3.1.1.9.5.2.2.7.4.3]
b. 29 Jan 1885
9
Abigail Benson
[1.1.3.1.1.9.5.2.3]
b. 2 Jul 1768
+
Henry Staples
9
Henry Staples Benson
[1.1.3.1.1.9.5.2.4]
b. 8 Aug 1770 d. 29 Jul 1821
Lydia Sibley
b. 2 Apr 1769 d. 27 Nov 1822
10
Abigail Benson
[1.1.3.1.1.9.5.2.4.1]
b. 31 Mar 1795 d. 10 Nov 1821
Asa Legg
b. 7 May 1792 d. 15 Nov 1836
11
Charlotte Legg
[1.1.3.1.1.9.5.2.4.1.1]
b. 2 May 1818 d. 30 Oct 1900
George Perrier Stawitts
b. 3 Jul 1820 d. 1897
12
Jacob Stawitts
[1.1.3.1.1.9.5.2.4.1.1.1]
b. Abt 1844
12
Cornelius Stanton Stawitts
[1.1.3.1.1.9.5.2.4.1.1.2]
b. 17 Feb 1846 d. 2 May 1914 [
=>
]
12
Herbert Stawitts
[1.1.3.1.1.9.5.2.4.1.1.3]
b. Abt 1848 d. Abt 1852
12
Emma Stawitts
[1.1.3.1.1.9.5.2.4.1.1.4]
b. Abt 1850
11
Lyman Legg
[1.1.3.1.1.9.5.2.4.1.2]
b. 3 Sep 1822 d. 1 Sep 1904
Hannah Thayer
b. 11 Feb 1820
12
Enoch J Legg
[1.1.3.1.1.9.5.2.4.1.2.1]
b. 25 Sep 1846
12
Enda Isadore Legg
[1.1.3.1.1.9.5.2.4.1.2.2]
b. 25 Sep 1846 d. 1 Sep 1914
12
Sarah Thayer Legg
[1.1.3.1.1.9.5.2.4.1.2.3]
b. 20 Oct 1850
10
Harriet Benson
[1.1.3.1.1.9.5.2.4.2]
b. 14 Sep 1796 d. 22 Aug 1852
10
Mellen Benson
[1.1.3.1.1.9.5.2.4.3]
b. 14 Jan 1798
Eliza W Farnum
b. 25 Sep 1802 d. 14 Sep 1839
11
Henry Staples Benson
[1.1.3.1.1.9.5.2.4.3.1]
b. 17 May 1829
11
Almira Farnum Benson
[1.1.3.1.1.9.5.2.4.3.2]
b. 6 Aug 1830 d. 25 Dec 1835
11
James Haskins Benson
[1.1.3.1.1.9.5.2.4.3.3]
b. 16 Oct 1833
11
George Everett Benson
[1.1.3.1.1.9.5.2.4.3.4]
b. 14 Aug 1837
+
Mary Windsor Peck
b. 21 May 1798
10
Hannah Adaline Benson
[1.1.3.1.1.9.5.2.4.4]
b. 12 Aug 1802 d. 19 Jun 1822
10
Rufus Benson
[1.1.3.1.1.9.5.2.4.5]
b. 24 Jan 1804 d. 23 Aug 1805
10
Chloe Ann Benson
[1.1.3.1.1.9.5.2.4.6]
b. 23 Aug 1806
+
Dan Hill
b. 29 Nov 1796
10
Susan Augusta Benson
[1.1.3.1.1.9.5.2.4.7]
b. 9 Oct 1809 d. 25 Jul 1831
Preserved Smith Thayer
b. 9 May 1808
11
Susan Benson Thayer
[1.1.3.1.1.9.5.2.4.7.1]
b. 28 Jun 1831 d. 14 Aug 1909
+
Daniel Wheelock Aldrich
b. 28 Aug 1822 d. 23 May 1891
10
Rufus Aldrich Benson
[1.1.3.1.1.9.5.2.4.8]
b. 9 Oct 1809
+
Sarah E Buell
10
Stephen Sibley Benson
[1.1.3.1.1.9.5.2.4.9]
b. 9 Jan 1810 d. 20 Nov 1869
Elizabeth Richardson Scott
b. 8 Jan 1835 d. 20 Feb 1911
11
Jessie Harriet Benson
[1.1.3.1.1.9.5.2.4.9.1]
b. 7 Jun 1860
+
John Robert Forbes Love
b. 22 Jun 1856
11
Fred Mellen Benson
[1.1.3.1.1.9.5.2.4.9.2]
b. 10 Nov 1862 d. 9 May 1864
11
Susie Adeline Benson
[1.1.3.1.1.9.5.2.4.9.3]
b. 6 Aug 1865
9
Tirza Benson
[1.1.3.1.1.9.5.2.5]
b. 29 Apr 1772
Wilder Johnson
b. 1768
10
Elmira Johnson
[1.1.3.1.1.9.5.2.5.1]
b. 1810 d. 27 May 1816
9
Susanna Thayer Benson
[1.1.3.1.1.9.5.2.6]
b. 19 Feb 1775
+
Gideon Angel
b. Abt 1770
9
Rachel Benson
[1.1.3.1.1.9.5.2.7]
b. 5 May 1777 d. 21 Nov 1842
General Charles Jenckes
b. 7 Aug 1767 d. 4 Jul 1838
10
Charles Benson Jenckes
[1.1.3.1.1.9.5.2.7.1]
b. 10 Apr 1796 d. Aft 1831
Hannah Ellis Thayer
b. 19 Mar 1800 d. 26 Feb 1818
11
Charles T Jenckes
[1.1.3.1.1.9.5.2.7.1.1]
b. 20 Feb 1818 d. 28 Feb 1818
Urana Thayer
b. 26 Dec 1801 d. 15 Nov 1822
11
Rufus A Jenckes
[1.1.3.1.1.9.5.2.7.1.2]
b. 22 Sep 1822 d. 11 Oct 1822
+
Alice T Thayer
b. Abt 1802 d. 28 Mar 1826
Ann Eliza Smith
b. 31 Dec 1805 d. 2 Apr 1865
11
Hannah Eliza Jenckes
[1.1.3.1.1.9.5.2.7.1.3]
b. 25 Nov 1827 d. 22 Oct 1890
+
Edwin Smith
b. Abt 1825
11
Charles Henry Jenckes
[1.1.3.1.1.9.5.2.7.1.4]
b. 17 Nov 1829 d. 1862
Susan Jenks
b. Abt 1831 d. 1919
12
Anna Maria Jencks
[1.1.3.1.1.9.5.2.7.1.4.1]
b. 31 Dec 1851 d. 31 Jul 1910
12
Henry Benson Jencks
[1.1.3.1.1.9.5.2.7.1.4.2]
b. 12 Jan 1861 d. 20 Jan 1925 [
=>
]
11
Ann Mariah Jenckes
[1.1.3.1.1.9.5.2.7.1.5]
b. 31 Dec 1831 d. 31 Jul 1910
Dr James Lucas Wheaton
b. 14 Mar 1823
12
Martha Jenckes Wheaton
[1.1.3.1.1.9.5.2.7.1.5.1]
b. 12 Feb 1851 [
=>
]
12
Anna Francis Wheaton
[1.1.3.1.1.9.5.2.7.1.5.2]
b. 27 Feb 1853 [
=>
]
12
Jesse L Wheaton
[1.1.3.1.1.9.5.2.7.1.5.3]
b. Dec 1860
12
James Lucas Wheaton, Jr
[1.1.3.1.1.9.5.2.7.1.5.4]
b. 9 Jul 1868 [
=>
]
8
Joanna Benson
[1.1.3.1.1.9.5.3]
b. 14 Nov 1745 d. Bef 1806
8
Benoni Benson
[1.1.3.1.1.9.5.4]
b. 11 Jul 1747 d. 1803
Ruth Holbrook
b. 10 Aug 1751 d. 16 May 1781
9
Amasa Benson
[1.1.3.1.1.9.5.4.1]
b. 25 Jan 1771 d. 7 Mar 1837
Levina Turtilot
b. 20 Feb 1777 d. 1 May 1865
10
Henry Holbrook Benson
[1.1.3.1.1.9.5.4.1.1]
b. 22 Mar 1801
Almira A
b. 26 Aug 1817
11
Leander A Benson
[1.1.3.1.1.9.5.4.1.1.1]
b. 1838 d. 10 Aug 1839
11
Henry A Benson
[1.1.3.1.1.9.5.4.1.1.2]
b. 23 Feb 1843 d. 19 Aug 1844
11
Seth Hall Benson
[1.1.3.1.1.9.5.4.1.1.3]
b. 6 Jul 1847 d. 1915
11
Edwin Benson
[1.1.3.1.1.9.5.4.1.1.4]
b. Abt 1851
10
James Davis Benson
[1.1.3.1.1.9.5.4.1.2]
b. 15 Nov 1802 d. 5 Sep 1805
10
Chloe Benson
[1.1.3.1.1.9.5.4.1.3]
b. 2 Oct 1804 d. 28 Mar 1844
Horace B Robbins
b. 28 Mar 1797 d. 24 Feb 1879
11
Alvin Cook Robbins
[1.1.3.1.1.9.5.4.1.3.1]
b. 12 May 1828
Mary L W Meggett
b. 1830
12
Mary E Robbins
[1.1.3.1.1.9.5.4.1.3.1.1]
b. Abt 1857
12
Arthur M Robbins
[1.1.3.1.1.9.5.4.1.3.1.2]
b. Abt 1858
12
Jennie T Robbins
[1.1.3.1.1.9.5.4.1.3.1.3]
b. Sep 1860
12
Annette C Robbins
[1.1.3.1.1.9.5.4.1.3.1.4]
b. Abt 1863
12
Wallace A Robbins
[1.1.3.1.1.9.5.4.1.3.1.5]
b. Dec 1869
11
Ann Mariah Robbins
[1.1.3.1.1.9.5.4.1.3.2]
b. 6 Jul 1830
11
Henry Davis Robbins
[1.1.3.1.1.9.5.4.1.3.3]
b. 22 Sep 1834
11
Charles W Robbins
[1.1.3.1.1.9.5.4.1.3.4]
b. Abt 1837
11
Sanford Augustus Robbins
[1.1.3.1.1.9.5.4.1.3.5]
b. 9 May 1840
10
Maria R Benson
[1.1.3.1.1.9.5.4.1.4]
b. 17 Dec 1806
Alvin Cook
b. 1805 d. 9 Jun 1872
11
Ellen L Cook
[1.1.3.1.1.9.5.4.1.4.1]
b. 1830
11
Miriam A Cook
[1.1.3.1.1.9.5.4.1.4.2]
b. Oct 1834 d. 24 Mar 1835
11
Aaron Cook
[1.1.3.1.1.9.5.4.1.4.3]
b. 26 Jun 1837
11
Samantha Maria Cook
[1.1.3.1.1.9.5.4.1.4.4]
b. Abt 1841
Caleb Edmund Thayer
b. 3 Sep 1841 d. 27 Aug 1868
12
Florence Thayer
[1.1.3.1.1.9.5.4.1.4.4.1]
b. Apr 1868
11
Alice Salina Cook
[1.1.3.1.1.9.5.4.1.4.5]
b. 26 Feb 1844
11
Winfield E Cook
[1.1.3.1.1.9.5.4.1.4.6]
b. 21 Jun 1847
11
Ellen Louisa Cooke
[1.1.3.1.1.9.5.4.1.4.7]
c. 3 Sep 1843
10
Charles Holbrook Benson
[1.1.3.1.1.9.5.4.1.5]
b. 14 Sep 1809
+
Adaline M Hayward
b. 22 Feb 1823
10
Angeline Benson
[1.1.3.1.1.9.5.4.1.6]
b. 20 Jul 1811
10
Ann Eliza Benson
[1.1.3.1.1.9.5.4.1.7]
b. 20 Feb 1813
10
Elsa T Benson
[1.1.3.1.1.9.5.4.1.8]
b. 17 Jul 1815
10
Nathan Benson
[1.1.3.1.1.9.5.4.1.9]
b. 30 Nov 1817
10
William Hall Benson
[1.1.3.1.1.9.5.4.1.10]
b. 24 Oct 1819
9
Chloe Benson
[1.1.3.1.1.9.5.4.2]
b. 28 Jan 1774
9
Benoni Benson
[1.1.3.1.1.9.5.4.3]
b. 1780 d. 1819
Ruth Sibley
b. 9 Apr 1745 d. 30 Nov 1814
9
John Benson
[1.1.3.1.1.9.5.4.4]
b. 1789
8
John Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5]
b. 1 Aug 1749 d. 18 May 1818
Mary Holbrook
b. 1 Feb 1762 d. 27 Dec 1814
9
John Perry Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1]
b. 22 Jul 1781 d. 21 Jan 1842
Chloe Taft
b. 7 Jul 1785 d. 25 Apr 1826
10
Charlotte Taft Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.1]
b. 30 Sep 1807 d. 16 Jul 1878
Moses Dyer
b. 1803 d. Aft 1841
11
Merril B Dyer
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.1.1]
b. 2 Apr 1844 d. 2 Apr 1859
11
George Franklin Dyer
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.1.2]
b. 22 Jan 1846 d. 27 Feb 1917
Ellen Jane Hubbard
b. 1848 d. 1925
12
Merrill Eugene Dyer
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.1.2.1]
b. 18 Dec 1869 d. 1926 [
=>
]
11
Chloe Allice Dyer
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.1.3]
b. 5 May 1848 d. 1932
Sanford Brown
b. 10 Feb 1844 d. 1883
12
Charlotta B Brown
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.1.3.1]
b. 22 Feb 1871
12
Paul Brown
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.1.3.2]
b. 12 Jan 1873 d. 24 Nov 1952 [
=>
]
12
Sanford Brown
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.1.3.3]
b. 17 Mar 1876 d. 5 Sep 1905
12
Elizabeth Brown
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.1.3.4]
b. 25 May 1879
12
Neil Brown
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.1.3.5]
b. 25 Mar 1882 d. 5 Nov 1913
11
Angelne A Dyer
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.1.4]
b. 6 Sep 1852
Orison J Batchelor
b. 11 Jul 1851 d. 10 Jan 1913
12
Chloe Edith Bachelor
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.1.4.1]
b. 11 Sep 1873
12
Nina F Bachelor
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.1.4.2]
b. 30 Nov 1875
12
Maria Frances Bachelor
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.1.4.3]
b. 30 Nov 1875
10
Ezra Taft Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2]
b. 22 Feb 1811 d. 3 Sep 1869
Pamelia Andrus
b. 21 Oct 1809 d. 14 Sep 1877
11
Charles Agustus Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.1]
b. 26 Sep 1832 d. 14 Oct 1833
11
Chloe Jane Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.2]
b. 1835 d. 1835
11
Charles Augustus Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.3]
b. 9 Jul 1837 d. 18 Feb 1873
11
Jonathan Parsons Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.4]
b. Mar 1841 d. Mar 1841
11
Adin Parsons Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.5]
b. Mar 1841 d. Mar 1841
11
Pamelia Emma Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.6]
b. 28 Feb 1842 d. 10 Feb 1892
11
Harvey Andrus Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.7]
b. 26 Sep 1844 d. 26 Sep 1844
11
Isabella Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.8]
b. 9 Mar 1846 d. 10 Feb 1922
11
Charlotte Taft Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.9]
b. 4 Jul 1850 d. 30 Nov 1918
Winfield Scott Norcross
b. 16 Jul 1844 d. 7 Jan 1915
12
Irving Norcross
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.9.1]
b. 1880
12
Winfield Irvin Norcross
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.9.2]
b. 18 Jun 1884
Adeline Brooks Andrus
b. 18 Mar 1813 d. 20 Apr 1898
11
George Taft Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.10]
b. 1 May 1846 d. 16 May 1919
Louisa Alexandrine Ballif
b. 25 Feb 1850 d. 7 Feb 1922
12
Louisa "Lulu" Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.10.1]
b. 28 Mar 1869 d. 15 Jul 1938 [
=>
]
12
Ezra Taft Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.10.2]
b. 6 Aug 1871 d. 28 Aug 1871
12
Elise Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.10.3]
b. 10 Mar 1873 d. 22 Aug 1937 [
=>
]
12
George Taft Benson, Jr
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.10.4]
b. 24 Jun 1875 d. 13 Aug 1934 [
=>
]
12
Serge Ballif Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.10.5]
b. 2 Oct 1877 d. 18 Jan 1959 [
=>
]
12
Adeline Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.10.6]
b. 31 Jul 1879 d. 27 Jan 1960 [
=>
]
12
Florence Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.10.7]
b. 31 Jul 1879 d. 5 Nov 1967 [
=>
]
12
William Kennedy Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.10.8]
b. 9 Feb 1882 d. 28 Feb 1882
12
Frank Taft Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.10.9]
b. 23 Apr 1883 d. 19 Feb 1923 [
=>
]
12
Marie Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.10.10]
b. 19 Jul 1885 d. 6 Mar 1891
12
Carmen Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.10.11]
b. 7 Nov 1887 d. 5 Jul 1974 [
=>
]
12
Jenny Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.10.12]
b. 30 Jun 1890 d. 12 Jul 1970 [
=>
]
12
Kathinka "Kinnie" Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.10.13]
b. 15 Mar 1894 d. 20 May 1960 [
=>
]
11
Florence Adeline Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.11]
b. 17 Sep 1851 d. 25 Dec 1852
11
Nellie Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.12]
b. 30 Nov 1851 d. 24 Jan 1885
11
Frank Andrus Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.13]
b. 16 Oct 1853 d. 5 May 1937
Amanda Charlotta Eliason
b. 4 Jun 1861 d. 12 Mar 1922
12
Eva A Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.13.1]
b. 6 Jul 1882 d. 10 Aug 1946
12
Blanche Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.13.2]
b. 7 May 1888 d. 12 Sep 1979
12
Edna Mae Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.13.3]
b. 19 Oct 1890 d. 19 Mar 1976
12
Frank Andrus Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.13.4]
b. 30 Apr 1895 d. 18 Dec 1968
12
Eleanora Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.13.5]
b. 30 Nov 1896 d. 2 Oct 1992
12
Karl Eliason Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.13.6]
b. 21 Apr 1899 d. 21 Oct 1980
12
Adeline Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.13.7]
b. 14 Mar 1904 d. 5 May 1904
12
George Taft Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.13.8]
b. 17 Aug 1905 d. 18 Feb 1942
11
Samuel Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.14]
b. 1853
Eliza Ann Perry
b. 30 Mar 1828 d. 30 Apr 1913
11
Alice Eliza Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.15]
b. 11 Aug 1848 d. 3 Jun 1923
11
John Perry Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.16]
b. 24 Sep 1849 d. 4 Jan 1921
11
Malina Adelaide Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.17]
b. 21 Sep 1851 d. 31 Jul 1918
11
Orrin William Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.18]
b. 4 Oct 1853 d. 17 May 1917
11
Carrie Stella Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.19]
b. 22 May 1860 d. 15 Mar 1928
11
Abbie Della Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.20]
b. 16 Oct 1862 d. 22 Oct 1925
11
Grace Ann Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.21]
b. 31 Jan 1867 d. 15 Dec 1924
Elizabeth Gollaher
b. 30 Dec 1831 d. 4 May 1904
11
Fredrick Gollaher Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.22]
b. 17 Jan 1855 d. 6 Jan 1915
11
Brigham Young Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.23]
b. 17 Dec 1858 d. 11 Jul 1938
11
Luella Gollaher Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.24]
b. 12 Nov 1860 d. 22 Jul 1881
11
William C Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.25]
b. 11 Nov 1862 d. Sep 1937
11
Hyrum Smith Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.26]
b. 3 May 1864 d. 4 May 1935
11
Edith Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.27]
b. 22 Apr 1867 d. 11 Feb 1925
11
Lizzie Gollaher Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.28]
b. 9 Jul 1869 d. 30 Jul 1946
Olive Mary Knight
b. 24 Jan 1830 d. 27 Mar 1905
11
Louisa Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.29]
b. 29 Jun 1852 d. 29 Nov 1878
11
Heber Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.30]
b. Abt 1860 d. Bef 1868
11
Moroni Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.31]
b. 5 Nov 1861 d. 8 Jan 1934
11
Lorenzo Taft Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.32]
b. 3 Aug 1863 d. 6 Nov 1950
11
Joseph Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.33]
b. 13 Jul 1865 d. 5 Jun 1941
11
Ida May Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.34]
b. 16 Apr 1867 d. 30 Jun 1929
11
Don Carlos Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.35]
b. 29 Sep 1869 d. 19 Jan 1935
Mary Marie Larsen
b. 19 Dec 1843 d. 21 Feb 1926
11
Walter Taft Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.36]
b. 17 Jun 1867 d. 6 Jun 1957
11
Henry Taft Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.2.37]
b. 19 Mar 1869 d. 24 Feb 1947
+
Desdemona Wadsworth Fullmer
b. 6 Oct 1809 d. 9 Feb 1886
+
Lucinda Burton
b. 22 Oct 1825 d. 1 Oct 1863
10
George Taft Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.3]
b. Abt 1813
Prudence Maria Gifford
b. Abt 1815
11
Walter Everet Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.3.1]
b. 13 Sep 1857 d. 29 Apr 1907
Laura Frances Caldwell
b. 1862
12
Laura Livice Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.3.1.1]
b. 9 Oct 1883 d. 14 Feb 1911 [
=>
]
12
George T Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.3.1.2]
b. Feb 1885
10
Hannah Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.4]
b. 18 Sep 1816
Henry Dodge
b. 15 Dec 1812 d. 22 Jun 1883
11
John M Dodge
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.4.1]
b. 1838 d. 14 Feb 1898
11
Abbie R Dodge
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.4.2]
b. 1850 d. 27 Sep 1916
John Averell
b. 1846 d. 19 Aug 1895
12
Elizabeth Alice Averell
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.4.2.1]
b. 13 Apr 1884 d. 4 Feb 1901
+
William Cotter Ball
b. 1865
10
Abbie Ann Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.5]
b. Abt 1809 d. 21 Sep 1883
Calvin Rawson
b. 13 May 1797 d. 21 Jan 1868
11
Son Rawson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.5.1]
b. Abt 1828 d. Abt 1838
10
John M Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.1.6]
b. 1819 d. 12 Aug 1829
9
George Washington Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.2]
b. 25 May 1783 d. 10 Nov 1855
Alinda Warfield
b. 24 Aug 1785 d. 25 Apr 1841
10
Otis Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.2.1]
b. 28 Feb 1806 d. 16 Feb 1811
10
Harrison Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.2.2]
b. 10 Oct 1820 d. 25 Oct 1859
Marilla Adams
b. 12 Apr 1818 d. 16 Oct 1876
11
George Otis Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.2.2.1]
b. 24 Aug 1846 d. 2 May 1897
11
Reuben Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.2.2.2]
b. 1 Jan 1856 d. 25 Jul 1922
+
Marietta Ingraham Bliss
b. 27 Jun 1856 d. 21 Oct 1931
9
Jared Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.3]
b. 3 Feb 1785 d. 31 Jul 1854
Salley Taft
b. 21 Oct 1787 d. 7 Aug 1855
10
James Sulliven Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.3.1]
b. 19 Sep 1808 d. 3 Jan 1833
10
Putman Taft Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.3.2]
b. 28 Oct 1814 d. 24 Apr 1834
10
Jared Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.3.3]
b. 8 Nov 1821 d. 18 May 1894
Martha Taft
b. 23 Feb 1826 d. 19 Feb 1903
11
Sullivan Theodore Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.3.3.1]
b. 20 Apr 1844 d. 21 Sep 1911
11
Jared Irving Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.3.3.2]
b. 6 Oct 1846 d. 1919
Jenny Aiken Guild
b. 1852 d. 27 Oct 1906
12
Jared Curtis Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.3.3.2.1]
b. 6 Oct 1877
12
Frank Theodore Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.3.3.2.2]
b. 25 Feb 1878 d. Jul 1949 [
=>
]
11
Walter Bryant Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.3.3.3]
b. 16 Jan 1850 d. 10 Feb 1860
11
Grace Sally Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.3.3.4]
b. 2 Sep 1852 d. 25 Feb 1863
10
Sylvanus Holbrook Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.3.4]
b. 23 Jun 1828 d. 1878
Laurett V Howard
b. 1830 d. 1860
11
Ellen Laura Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.3.4.1]
b. 18 Aug 1851
George Hawes Lapham
b. 12 Jul 1849
12
Hattie Cobb Lapham
[1.1.3.1.1.9.5.5.3.4.1.1]
b. 21 Oct 1873 d. 13 Jun 1906
12
Albert Francis Lapham
[1.1.3.1.1.9.5.5.3.4.1.2]
b. 11 Dec 1876 [
=>
]
12
Frank Atwood Lapham
[1.1.3.1.1.9.5.5.3.4.1.3]
b. 2 Oct 1878
12
Frederick Lapham
[1.1.3.1.1.9.5.5.3.4.1.4]
b. 2 Sep 1880
12
Daughter Lapham
[1.1.3.1.1.9.5.5.3.4.1.5]
b. 19 Nov 1882
12
William Lapham
[1.1.3.1.1.9.5.5.3.4.1.6]
b. 29 Apr 1884 d. Bef 1890
12
Teresa Lapham
[1.1.3.1.1.9.5.5.3.4.1.7]
b. 10 Dec 1886
12
William Lapham
[1.1.3.1.1.9.5.5.3.4.1.8]
b. 5 Nov 1890 d. 24 May 1898
11
Ernest S Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.3.4.2]
b. 25 May 1855
+
Ida Cornelia Furbish
b. 1858
11
Laurett Victoria Howard Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.3.4.3]
b. 1859 d. 3 Jul 1883
Ezra Hunt Bailey
b. 23 Dec 1853 d. 3 May 1929
12
Edith L Bailey
[1.1.3.1.1.9.5.5.3.4.3.1]
b. 19 Jan 1881 d. 1962
Lottie E. Kelly
11
Lottie E. Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.3.4.4]
b. 20 Sep 1866
9
Abigail Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.4]
b. 13 Feb 1787
Putman Taft
b. 5 Aug 1783 d. 20 Feb 1810
10
Mary Ann Taft
[1.1.3.1.1.9.5.5.4.1]
b. 23 Oct 1807
+
Samuel T Holroyd
b. 1791 d. 4 Nov 1817
+
Angel Sweet
b. 7 Apr 1790 d. 28 Apr 1825
+
Edward Ide Bower
+
Joseph McDermott
9
Mary "Polly" Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.5]
b. 9 Jun 1788 d. 12 Jan 1864
Bailey Legg
b. 9 May 1783 d. 11 Oct 1862
10
Sylvanus B Legg
[1.1.3.1.1.9.5.5.5.1]
b. 20 Jun 1813 d. Bef 8 Jun 1885
10
Mary H Legg
[1.1.3.1.1.9.5.5.5.2]
b. 7 Jul 1815
10
Harriet H Legg
[1.1.3.1.1.9.5.5.5.3]
b. 14 Jun 1817
9
Phyba Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.6]
b. Abt 1790
9
Prudence Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.7]
b. 7 Jul 1795
9
Thankful Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.8]
b. 26 Nov 1799 d. 1 May 1852
Joseph Bartlett Cook
b. 3 Dec 1796 d. 6 Oct 1856
10
William Walker Cook
[1.1.3.1.1.9.5.5.8.1]
b. 21 Mar 1820
Nancy Marion Draper
b. 17 Mar 1823
11
Edwin L Cook
[1.1.3.1.1.9.5.5.8.1.1]
b. 29 Mar 1857
+
Elisabeth M Campbell
b. Abt 1848
10
Amanda Melvina Cook
[1.1.3.1.1.9.5.5.8.2]
b. 12 Oct 1821
10
Mary Adeliza Cook
[1.1.3.1.1.9.5.5.8.3]
b. 18 Apr 1824
10
Emily Caroline Cook
[1.1.3.1.1.9.5.5.8.4]
b. 8 Feb 1826 d. 7 Mar 1826
10
Elma Ann Cook
[1.1.3.1.1.9.5.5.8.5]
b. 29 Jan 1827 d. 13 Jan 1870
William Gibbs Comstock
b. 3 Feb 1827 d. 29 Apr 1914
11
Alice Ardella Comstock
[1.1.3.1.1.9.5.5.8.5.1]
b. 10 Dec 1850 d. 20 Sep 1914
Sandford Phipps
b. 25 Aug 1850 d. 1919
12
Ross Elliot Phipps
[1.1.3.1.1.9.5.5.8.5.1.1]
b. 3 Sep 1877 d. 31 May 1958 [
=>
]
12
Edith Ardella Phipps
[1.1.3.1.1.9.5.5.8.5.1.2]
b. 12 Sep 1879
12
George Curtis Phipps
[1.1.3.1.1.9.5.5.8.5.1.3]
b. 25 Feb 1882 d. 4 Aug 1962
11
Fanny Amanda Comstock
[1.1.3.1.1.9.5.5.8.5.2]
b. 4 Jul 1854 d. 2 Sep 1934
9
Sulvanus Holbrook Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.9]
b. 12 Jan 1797 d. 24 Aug 1812
9
Judson Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.10]
b. Abt 1801 d. 15 Oct 1813
Joanna Taft
b. 14 Nov 1751 d. 3 Oct 1777
9
Lovett Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.11]
b. 6 Oct 1772 d. 4 Mar 1773
9
Lois Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.12]
b. 17 Jul 1774 d. 10 Jul 1840
Manassah Baker
b. 4 Oct 1765 d. 30 Jun 1831
10
Sarah Williams Baker
[1.1.3.1.1.9.5.5.12.1]
b. 8 Feb 1796
Andre Taft
b. 25 Jun 1792 d. 26 Jun 1850
11
Margary Ann Taft
[1.1.3.1.1.9.5.5.12.1.1]
b. 4 May 1818 d. 4 Nov 1904
Charles W Hartwell
b. 1816 d. Bef 1904
12
Margery Hartwell
[1.1.3.1.1.9.5.5.12.1.1.1]
b. 30 Oct 1849
11
Caroline Taft
[1.1.3.1.1.9.5.5.12.1.2]
b. 21 Aug 1821 d. 7 Nov 1907
John Flint Smith
b. 7 Nov 1815
12
Mary Flint Smith
[1.1.3.1.1.9.5.5.12.1.2.1]
b. 31 Mar 1850 d. 21 Aug 1852
12
Effie Caroline Smith
[1.1.3.1.1.9.5.5.12.1.2.2]
b. 28 Nov 1857 d. Aft 1902
10
Sawyer Baker
[1.1.3.1.1.9.5.5.12.2]
b. 5 Nov 1797 d. 14 Oct 1802
10
Mary Sawyer Baker
[1.1.3.1.1.9.5.5.12.3]
b. 1 Apr 1800
10
Bezaleel Sawyer Baker
[1.1.3.1.1.9.5.5.12.4]
b. 13 Sep 1802
10
William Henry Baker
[1.1.3.1.1.9.5.5.12.5]
b. 8 Jun 1805
10
Chloe Taft Baker
[1.1.3.1.1.9.5.5.12.6]
b. 17 Dec 1807
Faton Walker
11
Henry E Walker
[1.1.3.1.1.9.5.5.12.6.1]
b. 15 Mar 1836
11
Harriet E Walker
[1.1.3.1.1.9.5.5.12.6.2]
b. 15 Mar 1836 d. 30 Nov 1837
11
Edmund Walker
[1.1.3.1.1.9.5.5.12.6.3]
b. 18 Dec 1837 d. 10 May 1844
11
Edgar Walker
[1.1.3.1.1.9.5.5.12.6.4]
b. 18 Dec 1837 d. 24 Jan 1844
11
Adeline N Walker
[1.1.3.1.1.9.5.5.12.6.5]
b. 7 Feb 1845 d. 1848
10
John William Baker
[1.1.3.1.1.9.5.5.12.7]
b. 29 Sep 1810
10
Hannah Dike Baker
[1.1.3.1.1.9.5.5.12.8]
b. 8 Nov 1813 d. 3 Jul 1836
10
John Brooks Baker
[1.1.3.1.1.9.5.5.12.9]
b. 30 Jul 1816
10
Caleb Strong Baker
[1.1.3.1.1.9.5.5.12.10]
b. 30 Jul 1816 d. 29 Dec 1834
9
Prudence Benson
[1.1.3.1.1.9.5.5.13]
b. 4 May 1776 d. 16 May 1789
8
Ichabod Benson
[1.1.3.1.1.9.5.6]
b. 4 May 1751 d. Bef 1806
7
Sarah White
[1.1.3.1.1.9.6]
b. 8 Nov 1724
7
Ebenezer White
[1.1.3.1.1.9.7]
b. 20 Nov 1726 d. 10 May 1812
Elizabeth Ellis
b. 10 Dec 1729
8
Ellis White
[1.1.3.1.1.9.7.1]
b. 13 Oct 1748
8
Turner White
[1.1.3.1.1.9.7.2]
b. Abt 1750 d. 6 Aug 1836
8
Abigail White
[1.1.3.1.1.9.7.3]
b. 9 Sep 1752
8
Smith White
[1.1.3.1.1.9.7.4]
b. 9 Oct 1755 d. 18 Apr 1823
8
Philadelphia White
[1.1.3.1.1.9.7.5]
b. 6 Oct 1760
8
Melatiah White
[1.1.3.1.1.9.7.6]
b. Abt 18 May 1766
8
Stephen White
[1.1.3.1.1.9.7.7]
b. 11 May 1761 d. 20 Oct 1860
7
Prudence White
[1.1.3.1.1.9.8]
b. 24 Sep 1729 d. Feb 1787
James Albee
b. 12 Mar 1721 d. 24 Nov 1795
8
Hope Albee
[1.1.3.1.1.9.8.1]
b. Abt 1765 d. 18 Jan 1840
Stephen Holbrook
b. 19 Jun 1764 d. 16 Aug 1830
9
Rachel Holbrook
[1.1.3.1.1.9.8.1.1]
b. 22 Apr 1789
9
Sylvanus Holbrook
[1.1.3.1.1.9.8.1.2]
b. 28 Jul 1792 d. 9 Dec 1855
9
Willard Holbrook
[1.1.3.1.1.9.8.1.3]
b. 7 Apr 1795 d. 4 Mar 1862
9
Wilder Holbrook
[1.1.3.1.1.9.8.1.4]
b. 7 Apr 1795 d. 2 Jan 1855
9
Chloe Holbrook
[1.1.3.1.1.9.8.1.5]
b. 13 Aug 1801 d. 11 Aug 1855
9
Henry Holbrook
[1.1.3.1.1.9.8.1.6]
b. 19 Apr 1804 d. 10 Jul 1874
9
Ellery Holbrook
[1.1.3.1.1.9.8.1.7]
b. 26 Jun 1810 d. 10 Jul 1847
8
Rachael Albee
[1.1.3.1.1.9.8.2]
b. Abt 1748 d. 1832
8
Lois Albee
[1.1.3.1.1.9.8.3]
b. 15 Feb 1759 d. 1841
8
Eunice Albee
[1.1.3.1.1.9.8.4]
b. 20 Apr 1763 d. 1845
8
James Albee
[1.1.3.1.1.9.8.5]
b. 11 Mar 1753 d. 18 Aug 1814
8
Abigail Albee
[1.1.3.1.1.9.8.6]
b. 1747 d. 1844
8
Alpheus Albee
[1.1.3.1.1.9.8.7]
b. 15 Feb 1761 d. 1847
8
Prudance Albe
[1.1.3.1.1.9.8.8]
b. 18 Jan 1770 d. 1795
8
Abiel Albee
[1.1.3.1.1.9.8.9]
b. 1756 d. 1827
7
Rachael White
[1.1.3.1.1.9.9]
b. 14 Nov 1732 d. 19 Mar 1808
Thomas Darling
b. 7 May 1730 d. 22 Oct 1776
8
Seth Darling
[1.1.3.1.1.9.9.1]
b. 21 Mar 1764 d. 27 Mar 1825
8
Nathan Darling
[1.1.3.1.1.9.9.2]
b. 17 Dec 1770 d. 7 Sep 1855
8
Simeon Darling
[1.1.3.1.1.9.9.3]
b. 21 Mar 1760 d. 4 Jun 1812
8
John Darling
[1.1.3.1.1.9.9.4]
b. 9 Jun 1768
8
Alpheus Darling
[1.1.3.1.1.9.9.5]
b. Abt 1770
8
Rhoda Darling
[1.1.3.1.1.9.9.6]
b. 8 May 1750 d. 25 Jan 1842
8
Joanna Darling
[1.1.3.1.1.9.9.7]
b. 1 Feb 1752
8
Rachel Darling
[1.1.3.1.1.9.9.8]
b. 1 May 1755 d. Bef 1818
Reuben Holbrook
b. 18 Jul 1754 d. 1835
9
Abigail Holbrook
[1.1.3.1.1.9.9.8.1]
b. 8 Jan 1778
9
Rachael Holbrook
[1.1.3.1.1.9.9.8.2]
b. 8 Jan 1780
Foster Verry
b. 7 Oct 1789 d. 1860
10
Albert Verry
[1.1.3.1.1.9.9.8.2.1]
b. 15 Jul 1812
10
James Verry
[1.1.3.1.1.9.9.8.2.2]
b. 27 Feb 1814
Nancy Nolen
11
Ester Jane Verry
[1.1.3.1.1.9.9.8.2.2.1]
b. 19 Aug 1836 d. 10 Aug 1847
11
Isadore Verry
[1.1.3.1.1.9.9.8.2.2.2]
b. 10 Jul 1839
Daniel Bullard Pond
b. 23 Oct 1830
12
Verry Nolen Pond
[1.1.3.1.1.9.9.8.2.2.2.1]
b. 7 Jul 1862 d. 28 Feb 1866
12
Clarence Eli Pond
[1.1.3.1.1.9.9.8.2.2.2.2]
b. 14 Apr 1864 d. 19 Sep 1865
12
Isadore Maud Pond
[1.1.3.1.1.9.9.8.2.2.2.3]
b. 11 Sep 1868
12
Nancy May Pond
[1.1.3.1.1.9.9.8.2.2.2.4]
b. 19 May 1871
10
Chloe Holbrook Verry
[1.1.3.1.1.9.9.8.2.3]
b. 20 Mar 1816
David Smith Wilder
b. 20 Aug 1813 d. 13 Nov 1898
11
Albert Verry Wilder
[1.1.3.1.1.9.9.8.2.3.1]
b. 6 Feb 1838 d. Bef 1948
11
Foster Verry Wilder
[1.1.3.1.1.9.9.8.2.3.2]
b. 16 Apr 1839 d. Bef 1949
11
Abel Wilder
[1.1.3.1.1.9.9.8.2.3.3]
b. Abt 1840 d. Bef 1845
11
Chloeanna Wilder
[1.1.3.1.1.9.9.8.2.3.4]
b. Abt 1842 d. Bef 1846
11
Clara Deetta Wilder
[1.1.3.1.1.9.9.8.2.3.5]
b. Abt 1844 d. Bef 1850
11
Deetta Wilder
[1.1.3.1.1.9.9.8.2.3.6]
b. Abt 1845 d. Bef 1851
10
Sally Verry
[1.1.3.1.1.9.9.8.2.4]
b. 30 Apr 1818
10
Foster Verry
[1.1.3.1.1.9.9.8.2.5]
b. 3 Oct 1821 d. 29 Jun 1837
9
Prudence Holbrook
[1.1.3.1.1.9.9.8.3]
b. 25 Feb 1782
9
Anna Holbrook
[1.1.3.1.1.9.9.8.4]
b. 30 Mar 1784 d. 16 Mar 1851
Samuel Fairbanks
b. 8 Apr 1784 d. 22 Jul 1845
10
Samuel Fairbanks
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.1]
b. Feb 1803 d. Aft 1852
10
Hester Fairbanks
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.2]
b. 11 Apr 1804 d. Bef 1825
10
Mary Ann Fairbanks
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.3]
b. 27 Apr 1806 d. 1858
Elhanim Hartwell
b. 1819
11
Eunice Elsie Hartwell
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.3.1]
b. 7 May 1849
John M Proctor
b. 24 Sep 1825 d. 21 Jul 1907
12
Lena Esta Proctor
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.3.1.1]
b. 30 Nov 1874 d. 18 May 1936 [
=>
]
12
William Jay Proctor
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.3.1.2]
b. 3 Jan 1881 d. 26 Jan 1921 [
=>
]
10
Elizabeth Fairbanks
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.4]
b. 14 Nov 1814 d. 12 Oct 1872
Stewart Smiley
b. Abt 1808 d. 1892
11
William G Smiley
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.4.1]
11
Thomas J Smiley
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.4.2]
11
Charels E Smiley
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.4.3]
11
Stuart Smiley
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.4.4]
11
Adelbert Smiley
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.4.5]
11
Frank B Smiley
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.4.6]
11
Abbie Smiley
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.4.7]
11
George Smiley
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.4.8]
11
Adelia Smiley
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.4.9]
11
Melvina Smiley
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.4.10]
11
Susan Smiley
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.4.11]
11
Mary Ann Smiley
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.4.12]
11
Fredrick Lee Smiley
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.4.13]
b. 23 Oct 1853 d. 17 Jun 1903
Eliza J Metcalf
b. Abt 1860 d. 19 Jul 1926
12
Charles Smiley
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.4.13.1]
b. 1875
12
Earl Ray "Bert" Smiley
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.4.13.2]
b. 1879
12
Mabel Frances Smiley
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.4.13.3]
b. 12 Feb 1884 d. 23 Aug 1953 [
=>
]
12
Alice Smiley
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.4.13.4]
b. Dec 1882
12
Clarence Smiley
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.4.13.5]
b. Jun 1889
12
Harold Smiley
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.4.13.6]
b. Jul 1893
10
Benjamin Fairbanks
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.5]
b. 17 Feb 1808 d. 7 Oct 1876
Eunice Mead
b. 14 Jan 1811 d. 20 Aug 1893
11
Frances Adelia Fairbanks
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.5.1]
b. 10 Mar 1832
11
Anna Fairbanks
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.5.2]
b. 7 Sep 1833
11
Esther Fairbanks
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.5.3]
b. 9 Mar 1835
11
Samuel Fairbanks
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.5.4]
b. 21 Mar 1837 d. 27 Sep 1881
Harriet E Rounds
b. 29 Sep 1840
12
Mary Smiley Fairbanks
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.5.4.1]
b. 24 Nov 1862 d. 16 Mar 1870
12
Benjamin Rounds Fairbanks
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.5.4.2]
b. 2 Feb 1865
12
Emmay May Fairbanks
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.5.4.3]
b. 7 Nov 1872
12
Vinnie Lelia Fairbanks
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.5.4.4]
b. 7 Nov 1872
12
Ella Tucker Fairbanks
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.5.4.5]
b. 12 Apr 1881
11
Alfred Fairbanks
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.5.5]
b. 2 Jun 1839 d. 6 May 1864
11
Sarah Melissa Fairbanks
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.5.6]
b. 9 Aug 1843 d. 1921
Alanson Goodenow
b. Mar 1842 d. 1931
12
Chauncey B Goodenow
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.5.6.1]
b. Nov 1869 bur. 1934
11
Charles B Fairbanks
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.5.7]
b. 22 Sep 1846
Collena Russell
b. 26 Mar 1843
12
Minnie Bell Fairbanks
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.5.7.1]
b. 2 May 1867
12
Hiram Benjamin Fairbanks
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.5.7.2]
b. 2 Feb 1871
12
Florence Lena Fairbanks
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.5.7.3]
b. 26 Apr 1873
11
James Alonzo Fairbanks
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.5.8]
b. 14 Feb 1849
Sarah Williams
b. 27 Aug 1851
12
Nora E Fairbanks
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.5.8.1]
b. 3 Sep 1869 d. 13 Oct 1869
12
Blanche Estella Fairbanks
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.5.8.2]
b. 6 May 1872
12
Fannie Addessa Fairbanks
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.5.8.3]
b. 2 Apr 1874
12
Mark Roy Fairbanks
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.5.8.4]
b. 1 Nov 1876
10
Rachel Fairbanks
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.6]
b. 5 Jan 1810 d. Bef 1825
10
Reuben Fairbanks
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.7]
b. 2 Jun 1811 d. Bef 1825
10
Abbie Fairbanks
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.8]
b. Abt 1816
10
Charles Fairbanks
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.9]
b. 9 Mar 1817 d. 22 Oct 1869
Hanna Smith
b. Abt 1829
11
Delilah Fairbanks
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.9.1]
b. 1839
11
Esther Fairbanks
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.9.2]
b. 15 Dec 1841 d. 4 May 1912
11
Orlando Fairbanks
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.9.3]
b. 28 Dec 1842 d. 13 Feb 1871
11
Samuel Fairbanks
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.9.4]
b. 1844 d. 19 Feb 1923
11
Alice J Fairbanks
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.9.5]
b. 14 Apr 1847 d. 14 Feb 1897
Martin H Kilborn
b. 22 Feb 1845 d. 17 Dec 1910
12
Anna Belle Kilborn
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.9.5.1]
b. 22 Sep 1867 d. 11 Feb 1955 [
=>
]
12
Etta J Kilborn
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.9.5.2]
b. 22 Apr 1869 d. 5 Nov 1870
12
Myrtie L Kilborn
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.9.5.3]
b. 21 Aug 1875 d. 25 Dec 1924 [
=>
]
12
Leonora May Kilborn
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.9.5.4]
b. 23 May 1883
12
Nellie M Kilborn
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.9.5.5]
b. 23 May 1883 d. 26 Feb 1945 [
=>
]
11
Benjamin Fairbanks
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.9.6]
b. 3 Dec 1848 d. 3 Feb 1925
11
Abbey D Fairbanks
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.9.7]
b. 4 Feb 1851 d. 4 Nov 1860
11
Sibyl Fairbanks
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.9.8]
b. 30 Jun 1852 d. 30 Aug 1852
11
Libbie Fairbanks
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.9.9]
b. 1856
11
Addie Fairbanks
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.9.10]
11
Lee Fairbanks
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.9.11]
10
Abigail C Fairbanks
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.10]
b. 11 Aug 1825 d. 30 Jun 1848
David R Garrison
b. 1824 d. 1898
11
Mary Garrison
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.10.1]
b. 1844 d. 1876
11
Cornelius Garrison
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.10.2]
b. Abt 1849 d. 1928
11
Annie Garrison
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.10.3]
b. 1853
11
Sarah Ellen Garrison
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.10.4]
b. 31 Mar 1856
11
Willie Garrison
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.10.5]
b. 1858
11
Bennie Garrison
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.10.6]
b. 1860
11
Frank L Garrison
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.10.7]
b. 25 May 1862
11
Georgianne Garrison
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.10.8]
b. 11 Oct 1869
Horace B Andrews
b. 31 Oct 1866
12
Ether Andrews
[1.1.3.1.1.9.9.8.4.10.8.1]
b. 3 Mar 1894
9
Benjamin Holbrook
[1.1.3.1.1.9.9.8.5]
b. 31 Jan 1786
8
Prudence Darling
[1.1.3.1.1.9.9.9]
b. 28 Sep 1757 d. 1827
8
Benjamin Darling
[1.1.3.1.1.9.9.10]
b. 28 Feb 1766 d. Bef 14 Apr 1776
6
Lydia White
[1.1.3.1.1.10]
b. 10 May 1686
6
Thomas White
[1.1.3.1.1.11]
b. 26 Nov 1688 d. 10 Nov 1746
6
Hannah White
[1.1.3.1.1.12]
b. 9 Dec 1691 d. Abt 1761
6
Mary White
[1.1.3.1.1.13]
b. 1692 d. 1707
6
Abigail White
[1.1.3.1.1.14]
b. 10 Nov 1693 d. Bef 22 Mar 1720
6
Rachel White
[1.1.3.1.1.15]
b. 27 Dec 1694
5
Thomas White
[1.1.3.1.2]
b. 8 May 1680 d. 31 Mar 1762
5
Cornelius White
[1.1.3.1.3]
b. 28 Mar 1682 d. 21 Jan 1755
5
Benjamin White
[1.1.3.1.4]
b. 12 Oct 1684 d. 12 May 1724
5
Eleazar White
[1.1.3.1.5]
b. 8 Nov 1686 d. 14 Apr 1737
5
Ebenezer White
[1.1.3.1.6]
b. 3 Aug 1691 d. 18 May 1733
4
Jonathan White
[1.1.3.2]
b. 4 Jun 1658 d. Bef 22 Feb 1737
4
Peregrine White, Jr
[1.1.3.3]
b. 19 Dec 1662 d. 20 Nov 1727
4
Sarah White
[1.1.3.4]
b. Oct 1663 d. 9 Aug 1755
4
Sylvanus White
[1.1.3.5]
b. 1667 d. 29 Jun 1688
4
Mercy White
[1.1.3.6]
b. 3 Feb 1670 d. 12 Jun 1739
3
Nathaniel Bassett
[1.1.4]
b. Abt 1630 d. 17 Jan 1710
3
Ruth Bassett
[1.1.5]
b. 13 Nov 1633 d. 26 Mar 1676
John Sprague
b. Abt 1630 d. 26 Mar 1676
4
Elizabeth Sprague
[1.1.5.1]
b. Abt 1655 d. 27 May 1727
Stephen Samson
b. Abt 1653 d. Bef 31 Jan 1714
5
Benjamin Sampson
[1.1.5.1.1]
b. 19 Sep 1686 d. 19 Apr 1758
5
John Sampson
[1.1.5.1.2]
b. 17 Aug 1688 d. 26 Jan 1770
5
Cornelius Sampson
[1.1.5.1.3]
b. Abt 1690 d. Bef 12 Mar 1724
5
Hannah Sampson
[1.1.5.1.4]
b. Abt 1692
5
Mary Sampson
[1.1.5.1.5]
b. Abt 1694 d. 12 Mar 1723
Samuel Thayer
b. 28 Mar 1696 d. 21 Jun 1764
6
Abigail Thayer
[1.1.5.1.5.1]
b. 22 Aug 1718 d. 11 Mar 1774
John Partridge
b. 2 Jun 1715 d. 21 Dec 1791
7
John Partridge
[1.1.5.1.5.1.1]
b. Abt 1737 d. 14 May 1764
7
Asa Partridge
[1.1.5.1.5.1.2]
b. 24 Jul 1740 d. 10 Dec 1746
7
Joseph Partridge
[1.1.5.1.5.1.3]
b. 26 Oct 1742 d. 10 Oct 1746
7
Samuel Partridge
[1.1.5.1.5.1.4]
b. 15 Apr 1743 d. 15 Apr 1744
7
Stephen Partridge
[1.1.5.1.5.1.5]
b. 15 Apr 1744 d. 15 Apr 1744
7
Abigail Partridge
[1.1.5.1.5.1.6]
b. 26 Oct 1745 d. 20 Feb 1746
7
Micah Partridge
[1.1.5.1.5.1.7]
b. 20 Dec 1746 d. 20 Dec 1746
7
Abigail Allen Partridge
[1.1.5.1.5.1.8]
b. 23 Jan 1754 d. 12 May 1802
6
Samuel Thayer
[1.1.5.1.5.2]
b. 10 Jun 1721 bur. 24 Nov 1789
Sarah Farnham
b. 20 Jul 1736 d. 1778
7
Amos Thayer
[1.1.5.1.5.2.1]
b. 19 Aug 1757 d. 11 Jul 1838
7
Jabes Thayer
[1.1.5.1.5.2.2]
b. Abt 1758 d. 1778
7
Asa Thayer
[1.1.5.1.5.2.3]
b. 4 Oct 1761 d. 9 Apr 1828
Mary Murdock
b. 15 Jun 1764 d. 26 Jul 1844
8
Olive Thayer
[1.1.5.1.5.2.3.1]
b. 10 Aug 1782 d. 1865
+
Ezekial Taft
b. 21 Jan 1777 d. 24 Apr 1841
8
Clinton Thayer
[1.1.5.1.5.2.3.2]
b. 27 Apr 1784 d. 7 Mar 1835
8
Nancy Thayer
[1.1.5.1.5.2.3.3]
b. 1786 d. 1852
Arnold Taft
b. 3 Feb 1793 d. 4 Feb 1865
9
Mary Thayer
[1.1.5.1.5.2.3.3.1]
b. 20 Sep 1820 d. 10 Oct 1888
Nehemiah White Lee
b. 16 Mar 1819 d. 20 Apr 1890
10
Charles Arnold Lee
[1.1.5.1.5.2.3.3.1.1]
b. 14 Dec 1845 d. 16 May 1900
Phebe Sprague Wright
b. Feb 1844 d. 23 Apr 1916
11
Mabel Cunier Lee
[1.1.5.1.5.2.3.3.1.1.1]
b. 12 May 1876
11
Charles Weight Lee
[1.1.5.1.5.2.3.3.1.1.2]
b. 12 May 1876
10
Walter Orman Lee
[1.1.5.1.5.2.3.3.1.2]
b. 6 Feb 1848 d. 16 Apr 1881
Elizabeth H Monkhouse
b. 27 Oct 1846 d. 3 Jul 1895
11
Walter Nehemiah Lee
[1.1.5.1.5.2.3.3.1.2.1]
b. 16 Sep 1873 d. 5 Nov 1960
Ann Ellen Jackson
b. 8 Jul 1878 d. 24 Oct 1954
12
Edith E Lee
[1.1.5.1.5.2.3.3.1.2.1.1]
b. 31 Dec 1897 d. 6 Apr 1961 [
=>
]
12
Walter Orman Lee
[1.1.5.1.5.2.3.3.1.2.1.2]
b. 31 May 1900 d. 14 Nov 1985 [
=>
]
12
Albert Hillman Lee
[1.1.5.1.5.2.3.3.1.2.1.3]
b. 13 Dec 1909 d. 4 Jun 1998
12
Ralph L Lee
[1.1.5.1.5.2.3.3.1.2.1.4]
b. 10 Sep 1911 d. Apr 1979
12
Alma I Lee
[1.1.5.1.5.2.3.3.1.2.1.5]
b. 27 Mar 1915 d. May 1980
10
Harrit Taft Lee
[1.1.5.1.5.2.3.3.1.3]
b. 4 May 1852 d. 8 Apr 1888
10
Joseph Newton Lee
[1.1.5.1.5.2.3.3.1.4]
b. 25 Feb 1864 d. Sep 1943
10
Mary Anna Elizabeth Lee
[1.1.5.1.5.2.3.3.1.5]
b. 30 Nov 1859 d. 29 Jun 1945
Edwin Francis Carpenter
b. 1854 d. 7 Aug 1919
11
Bertha Lee Carpenter
[1.1.5.1.5.2.3.3.1.5.1]
b. 26 Jun 1883 d. 10 May 1960
+
George C Carpenter
b. 18 Sep 1875 d. 1 Nov 1930
11
Louisa O Carpenter
[1.1.5.1.5.2.3.3.1.5.2]
b. 15 Oct 1886
11
Lewis Ormand Carpenter
[1.1.5.1.5.2.3.3.1.5.3]
b. 15 Oct 1886 d. 5 Sep 1965
+
Bessie May Newell
b. 3 Aug 1898 d. 9 Jan 1982
11
Edith Malora Carpenter
[1.1.5.1.5.2.3.3.1.5.4]
b. 14 Feb 1899 d. 7 May 1986
8
Royal Thayer
[1.1.5.1.5.2.3.4]
b. 1787
8
Sullivan Thayer
[1.1.5.1.5.2.3.5]
b. 3 Apr 1792 d. 7 Nov 1865
8
Emery Thayer
[1.1.5.1.5.2.3.6]
b. 19 Feb 1794 d. 12 Aug 1862
8
Louis Thayer
[1.1.5.1.5.2.3.7]
b. 3 Oct 1796 d. 1832
8
Mary M Thayer
[1.1.5.1.5.2.3.8]
b. Abt 1799 d. 1885
8
Asa Thayer
[1.1.5.1.5.2.3.9]
b. 2 Sep 1799 d. 1871
8
Turner Thayer
[1.1.5.1.5.2.3.10]
b. 2 Feb 1802 d. 8 Dec 1853
8
Lovisa Thayer
[1.1.5.1.5.2.3.11]
b. 4 Apr 1806 d. 1828
8
Collins Thayer
[1.1.5.1.5.2.3.12]
b. 7 Apr 1790 d. 19 Sep 1855
Almira Taft
b. 9 Jun 1800 d. 1873
9
Adeline Thayer
[1.1.5.1.5.2.3.12.1]
b. 1817
9
Virginia Thayer
[1.1.5.1.5.2.3.12.2]
b. 1821
9
Elizabeth Thayer
[1.1.5.1.5.2.3.12.3]
b. 1823
9
Collins Thayer
[1.1.5.1.5.2.3.12.4]
b. 1825
9
Susan Thayer
[1.1.5.1.5.2.3.12.5]
b. 27 Dec 1826
Charles Henry Guild
b. 25 Mar 1823
10
Virginia Melora Guild
[1.1.5.1.5.2.3.12.5.1]
b. 22 Dec 1846 d. 17 Jul 1929
10
Charles Samuel Guild
[1.1.5.1.5.2.3.12.5.2]
b. 18 Oct 1848
10
Willard Temple Guild
[1.1.5.1.5.2.3.12.5.3]
b. 12 Feb 1855 d. 29 Jun 1855
9
Olive A Thayer
[1.1.5.1.5.2.3.12.6]
b. Abt 1827
9
Mary Thayer
[1.1.5.1.5.2.3.12.7]
b. 1828
Almarine A Gwaltney
b. 1824
10
James A Gwaltney
[1.1.5.1.5.2.3.12.7.1]
b. 1851
10
Ella Gwaltney
[1.1.5.1.5.2.3.12.7.2]
b. 9 Feb 1856 d. 1920
10
Luther Gwaltney
[1.1.5.1.5.2.3.12.7.3]
b. Mar 1858
Laura S Kremer
b. Dec 1859
11
Luther Thayer Gwaltney
[1.1.5.1.5.2.3.12.7.3.1]
b. 16 Jun 1890 d. Aug 1971
+
Marguerite
b. 1901
11
Howell Corbin Gwaltney
[1.1.5.1.5.2.3.12.7.3.2]
b. 9 Oct 1893
+
Margaret S. Bell
b. 11 Apr 1896 d. 12 Sep 1989
10
Frances Gwaltney
[1.1.5.1.5.2.3.12.7.4]
b. 1860
10
Georgia Gwaltney
[1.1.5.1.5.2.3.12.7.5]
b. Feb 1863 d. 1940
10
Susie Gwaltney
[1.1.5.1.5.2.3.12.7.6]
b. 1864
9
Almira Thayer
[1.1.5.1.5.2.3.12.8]
b. 1831 d. 1895
7
Samuel Thayer
[1.1.5.1.5.2.4]
b. 6 Sep 1762 d. 1830
+
Rebecca Howe
b. 4 Dec 1763 d. 17 Aug 1829
7
Loies Thayer
[1.1.5.1.5.2.5]
b. 15 Feb 1764 d. 1837
7
Polly Thayer
[1.1.5.1.5.2.6]
b. 18 Feb 1766 d. 1843
7
Eunice Thayer
[1.1.5.1.5.2.7]
b. 1768 d. 1841
7
Louisa Thayer
[1.1.5.1.5.2.8]
b. 1774 d. 1829
6
Zilphah Thayer
[1.1.5.1.5.3]
b. 14 Sep 1722 d. 1761
John Holbrook
b. 1 Aug 1717 d. 1773
7
Micah Holbrook
[1.1.5.1.5.3.1]
b. 11 Mar 1744
7
Amariah Holbrook
[1.1.5.1.5.3.2]
b. Abt 1745 d. 20 Jan 1817
7
John Holbrook
[1.1.5.1.5.3.3]
b. Jun 1748
7
Catharina Holbrook
[1.1.5.1.5.3.4]
b. Abt 1752 d. 1752
7
Rhoda Holbrook
[1.1.5.1.5.3.5]
b. 25 Aug 1758 d. 1807
6
Mary Thayer
[1.1.5.1.5.4]
b. 12 Feb 1723 d. 7 Aug 1764
6
Thankful Thayer
[1.1.5.1.5.5]
b. 4 Aug 1725 d. 10 Dec 1798
Sylvanus Holbrook
b. 13 May 1713 d. 1782
7
Sylvanus Holbrook
[1.1.5.1.5.5.1]
b. 21 Apr 1750 d. 1828
Mary Thayer
b. 7 Jun 1749 d. 26 May 1831
8
Phebe Holbrook
[1.1.5.1.5.5.1.1]
b. 16 Feb 1773 d. 25 Oct 1832
8
Ezekiel Holbrook
[1.1.5.1.5.5.1.2]
b. 18 Apr 1777 d. 1799
8
Joseph Holbrook
[1.1.5.1.5.5.1.3]
b. 6 Nov 1781
8
Polly Holbrook
[1.1.5.1.5.5.1.4]
b. 1783
8
Mary Holbrook
[1.1.5.1.5.5.1.5]
b. 16 Oct 1784 d. 15 Aug 1844
7
Ruth Holbrook
[1.1.5.1.5.5.2]
b. 10 Aug 1751 d. 16 May 1781
Benoni Benson
b. 11 Jul 1747 d. 1803
8
Amasa Benson
[1.1.5.1.5.5.2.1]
b. 25 Jan 1771 d. 7 Mar 1837
Levina Turtilot
b. 20 Feb 1777 d. 1 May 1865
9
Henry Holbrook Benson
[1.1.5.1.5.5.2.1.1]
b. 22 Mar 1801
Almira A
b. 26 Aug 1817
10
Leander A Benson
[1.1.5.1.5.5.2.1.1.1]
b. 1838 d. 10 Aug 1839
10
Henry A Benson
[1.1.5.1.5.5.2.1.1.2]
b. 23 Feb 1843 d. 19 Aug 1844
10
Seth Hall Benson
[1.1.5.1.5.5.2.1.1.3]
b. 6 Jul 1847 d. 1915
10
Edwin Benson
[1.1.5.1.5.5.2.1.1.4]
b. Abt 1851
9
James Davis Benson
[1.1.5.1.5.5.2.1.2]
b. 15 Nov 1802 d. 5 Sep 1805
9
Chloe Benson
[1.1.5.1.5.5.2.1.3]
b. 2 Oct 1804 d. 28 Mar 1844
Horace B Robbins
b. 28 Mar 1797 d. 24 Feb 1879
10
Alvin Cook Robbins
[1.1.5.1.5.5.2.1.3.1]
b. 12 May 1828
Mary L W Meggett
b. 1830
11
Mary E Robbins
[1.1.5.1.5.5.2.1.3.1.1]
b. Abt 1857
11
Arthur M Robbins
[1.1.5.1.5.5.2.1.3.1.2]
b. Abt 1858
11
Jennie T Robbins
[1.1.5.1.5.5.2.1.3.1.3]
b. Sep 1860
+
Charles L Browning
b. Jun 1840 d. 24 Oct 1903
11
Annette C Robbins
[1.1.5.1.5.5.2.1.3.1.4]
b. Abt 1863
11
Wallace A Robbins
[1.1.5.1.5.5.2.1.3.1.5]
b. Dec 1869
10
Ann Mariah Robbins
[1.1.5.1.5.5.2.1.3.2]
b. 6 Jul 1830
10
Henry Davis Robbins
[1.1.5.1.5.5.2.1.3.3]
b. 22 Sep 1834
10
Charles W Robbins
[1.1.5.1.5.5.2.1.3.4]
b. Abt 1837
10
Sanford Augustus Robbins
[1.1.5.1.5.5.2.1.3.5]
b. 9 May 1840
9
Maria R Benson
[1.1.5.1.5.5.2.1.4]
b. 17 Dec 1806
Alvin Cook
b. 1805 d. 9 Jun 1872
10
Ellen L Cook
[1.1.5.1.5.5.2.1.4.1]
b. 1830
10
Miriam A Cook
[1.1.5.1.5.5.2.1.4.2]
b. Oct 1834 d. 24 Mar 1835
10
Aaron Cook
[1.1.5.1.5.5.2.1.4.3]
b. 26 Jun 1837
10
Samantha Maria Cook
[1.1.5.1.5.5.2.1.4.4]
b. Abt 1841
Caleb Edmund Thayer
b. 3 Sep 1841 d. 27 Aug 1868
11
Florence Thayer
[1.1.5.1.5.5.2.1.4.4.1]
b. Apr 1868
10
Alice Salina Cook
[1.1.5.1.5.5.2.1.4.5]
b. 26 Feb 1844
10
Winfield E Cook
[1.1.5.1.5.5.2.1.4.6]
b. 21 Jun 1847
10
Ellen Louisa Cooke
[1.1.5.1.5.5.2.1.4.7]
c. 3 Sep 1843
9
Charles Holbrook Benson
[1.1.5.1.5.5.2.1.5]
b. 14 Sep 1809
+
Adaline M Hayward
b. 22 Feb 1823
9
Angeline Benson
[1.1.5.1.5.5.2.1.6]
b. 20 Jul 1811
9
Ann Eliza Benson
[1.1.5.1.5.5.2.1.7]
b. 20 Feb 1813
9
Elsa T Benson
[1.1.5.1.5.5.2.1.8]
b. 17 Jul 1815
9
Nathan Benson
[1.1.5.1.5.5.2.1.9]
b. 30 Nov 1817
9
William Hall Benson
[1.1.5.1.5.5.2.1.10]
b. 24 Oct 1819
8
Chloe Benson
[1.1.5.1.5.5.2.2]
b. 28 Jan 1774
8
Benoni Benson
[1.1.5.1.5.5.2.3]
b. 1780 d. 1819
7
Rachel Holbrook
[1.1.5.1.5.5.3]
b. 6 Nov 1753 d. 9 Mar 1832
Jonathan Staples
b. 29 Mar 1754 d. 28 Nov 1832
8
Sally Staples
[1.1.5.1.5.5.3.1]
b. 3 Oct 1779
8
Sylvia Staples
[1.1.5.1.5.5.3.2]
b. 2 Jan 1781 d. 13 Mar 1852
8
Rachael Staples
[1.1.5.1.5.5.3.3]
b. Abt 1784 d. 12 Dec 1870
8
Ellery Staples
[1.1.5.1.5.5.3.4]
b. 1784 d. 1861
8
Willard Staples
[1.1.5.1.5.5.3.5]
b. 20 Dec 1785 d. 20 Dec 1858
8
Jonathan Staples
[1.1.5.1.5.5.3.6]
b. 1792
7
Comfort Holbrook
[1.1.5.1.5.5.4]
b. 12 Mar 1756
7
Margaret Holbrook
[1.1.5.1.5.5.5]
b. 14 Aug 1757 d. Abt 1805
Thadaus Thayer
b. 1 Feb 1754 d. 24 Dec 1826
8
George Thayer
[1.1.5.1.5.5.5.1]
b. 20 Jul 1779 d. 27 May 1836
8
Otis Thayer
[1.1.5.1.5.5.5.2]
b. 17 Mar 1780 d. 13 Apr 1841
8
Arkey Thayer
[1.1.5.1.5.5.5.3]
b. 6 Dec 1781 d. 1783
8
Ellis Holbrook Thayer
[1.1.5.1.5.5.5.4]
b. 9 Mar 1783 d. 2 Jul 1863
8
Ruth Thayer
[1.1.5.1.5.5.5.5]
b. Abt 1784 d. 1821
8
Sylvanus Thayer
[1.1.5.1.5.5.5.6]
b. Abt 1786 d. 7 Mar 1859
8
Margaret Thayer
[1.1.5.1.5.5.5.7]
b. 11 Nov 1787
8
Thaddeus Thayer
[1.1.5.1.5.5.5.8]
b. Nov 1789 d. 4 Mar 1824
8
Margery Thayer
[1.1.5.1.5.5.5.9]
b. 2 May 1792
8
Maranda Thayer
[1.1.5.1.5.5.5.10]
b. Abt 1794
8
Barbara Thayer
[1.1.5.1.5.5.5.11]
b. 25 Jun 1797 d. 1822
8
Diana Thayer
[1.1.5.1.5.5.5.12]
b. 6 Jan 1800 d. 17 Nov 1861
7
Thankful Holbrook
[1.1.5.1.5.5.6]
b. 23 Feb 1760 d. 25 May 1834
David Legg
b. 11 May 1756 d. 25 Apr 1844
8
Thankful Holbrook Legg
[1.1.5.1.5.5.6.1]
b. Abt 1803
7
Mary Holbrook
[1.1.5.1.5.5.7]
b. 1 Feb 1762 d. 27 Dec 1814
John Benson
b. 1 Aug 1749 d. 18 May 1818
8
John Perry Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1]
b. 22 Jul 1781 d. 21 Jan 1842
Chloe Taft
b. 7 Jul 1785 d. 25 Apr 1826
9
Charlotte Taft Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.1]
b. 30 Sep 1807 d. 16 Jul 1878
Moses Dyer
b. 1803 d. Aft 1841
10
Merril B Dyer
[1.1.5.1.5.5.7.1.1.1]
b. 2 Apr 1844 d. 2 Apr 1859
10
George Franklin Dyer
[1.1.5.1.5.5.7.1.1.2]
b. 22 Jan 1846 d. 27 Feb 1917
Ellen Jane Hubbard
b. 1848 d. 1925
11
Merrill Eugene Dyer
[1.1.5.1.5.5.7.1.1.2.1]
b. 18 Dec 1869 d. 1926
Lena Hartshorn
b. 1872
12
Hazel Dyer
[1.1.5.1.5.5.7.1.1.2.1.1]
b. 5 Sep 1899 d. 24 Oct 1984
12
Leo Carlton Dyer
[1.1.5.1.5.5.7.1.1.2.1.2]
b. 22 Jan 1902 d. 18 Jul 1910
12
Clara Dyer
[1.1.5.1.5.5.7.1.1.2.1.3]
b. 15 Dec 1902 d. 24 Jul 1998
10
Chloe Allice Dyer
[1.1.5.1.5.5.7.1.1.3]
b. 5 May 1848 d. 1932
Sanford Brown
b. 10 Feb 1844 d. 1883
11
Charlotta B Brown
[1.1.5.1.5.5.7.1.1.3.1]
b. 22 Feb 1871
+
Clements Roehrig
b. 1869
11
Paul Brown
[1.1.5.1.5.5.7.1.1.3.2]
b. 12 Jan 1873 d. 24 Nov 1952
Beatrice Hart
b. 1872
12
Ruth Brown
[1.1.5.1.5.5.7.1.1.3.2.1]
b. 18 Aug 1899
11
Sanford Brown
[1.1.5.1.5.5.7.1.1.3.3]
b. 17 Mar 1876 d. 5 Sep 1905
+
Clara Marie Perry
b. Dec 1875
11
Elizabeth Brown
[1.1.5.1.5.5.7.1.1.3.4]
b. 25 May 1879
+
Alfred E Truman
b. 1877
11
Neil Brown
[1.1.5.1.5.5.7.1.1.3.5]
b. 25 Mar 1882 d. 5 Nov 1913
10
Angelne A Dyer
[1.1.5.1.5.5.7.1.1.4]
b. 6 Sep 1852
Orison J Batchelor
b. 11 Jul 1851 d. 10 Jan 1913
11
Chloe Edith Bachelor
[1.1.5.1.5.5.7.1.1.4.1]
b. 11 Sep 1873
11
Nina F Bachelor
[1.1.5.1.5.5.7.1.1.4.2]
b. 30 Nov 1875
11
Maria Frances Bachelor
[1.1.5.1.5.5.7.1.1.4.3]
b. 30 Nov 1875
9
Ezra Taft Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2]
b. 22 Feb 1811 d. 3 Sep 1869
Pamelia Andrus
b. 21 Oct 1809 d. 14 Sep 1877
10
Charles Agustus Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.1]
b. 26 Sep 1832 d. 14 Oct 1833
10
Chloe Jane Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.2]
b. 1835 d. 1835
10
Charles Augustus Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.3]
b. 9 Jul 1837 d. 18 Feb 1873
10
Jonathan Parsons Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.4]
b. Mar 1841 d. Mar 1841
10
Adin Parsons Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.5]
b. Mar 1841 d. Mar 1841
10
Pamelia Emma Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.6]
b. 28 Feb 1842 d. 10 Feb 1892
10
Harvey Andrus Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.7]
b. 26 Sep 1844 d. 26 Sep 1844
10
Isabella Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.8]
b. 9 Mar 1846 d. 10 Feb 1922
10
Charlotte Taft Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.9]
b. 4 Jul 1850 d. 30 Nov 1918
Winfield Scott Norcross
b. 16 Jul 1844 d. 7 Jan 1915
11
Irving Norcross
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.9.1]
b. 1880
11
Winfield Irvin Norcross
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.9.2]
b. 18 Jun 1884
Adeline Brooks Andrus
b. 18 Mar 1813 d. 20 Apr 1898
10
George Taft Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10]
b. 1 May 1846 d. 16 May 1919
Louisa Alexandrine Ballif
b. 25 Feb 1850 d. 7 Feb 1922
11
Louisa "Lulu" Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.1]
b. 28 Mar 1869 d. 15 Jul 1938
William Chandler Parkinson
b. 2 Aug 1855 d. 18 Nov 1929
12
Louisa Benson Parkinson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.1.1]
b. 5 Jul 1889 d. 12 Sep 1973 [
=>
]
12
Marie Benson Parkinson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.1.2]
b. 13 Dec 1891 d. 22 Jan 1919
12
Charlotte Benson Parkinson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.1.3]
b. 16 Jul 1894 d. 13 Oct 1980
12
Clara Parkinson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.1.4]
b. 8 Aug 1897 d. 6 Oct 1992 [
=>
]
12
George Benson Parkinson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.1.5]
b. 17 Oct 1899 d. 31 Oct 1918
12
Adeline Parkinson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.1.6]
b. 2 Jan 1902 d. 27 Apr 1990 [
=>
]
12
Wilbur Chandler Parkinson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.1.7]
b. 10 Oct 1904 d. 20 Dec 1988 [
=>
]
12
Carmen Parkinson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.1.8]
b. 5 Oct 1907 d. 24 Mar 1993 [
=>
]
12
Evelyn Parkinson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.1.9]
b. 30 Mar 1910 d. 30 Jun 1991
12
Wanda Parkinson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.1.10]
b. 31 Jul 1911 d. 13 Jun 1995 [
=>
]
11
Ezra Taft Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.2]
b. 6 Aug 1871 d. 28 Aug 1871
11
Elise Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.3]
b. 10 Mar 1873 d. 22 Aug 1937
George Alfred Alder, Jr
b. 4 Jan 1874 d. 3 May 1940
12
Ione Benson Alder
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.3.1]
b. 9 Jul 1896 d. 6 Oct 1983 [
=>
]
12
Lydia Dunford Alder
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.3.2]
b. 30 Nov 1898 d. 7 Aug 1983
12
Linden Benson Alder
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.3.3]
b. 20 Mar 1900 d. 8 Aug 1957 [
=>
]
12
Garold Benson Alder
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.3.4]
b. 2 May 1902 d. 12 Jun 1960 [
=>
]
12
George Benson Alder
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.3.5]
b. 1 May 1906 d. 11 Nov 1974 [
=>
]
12
Ballif Benson Alder
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.3.6]
b. 1 May 1906 d. 23 Nov 1906
12
Donald Benson Alder
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.3.7]
b. 4 Dec 1908 d. 14 Mar 1993 [
=>
]
12
George Alfred Alder
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.3.8]
b. 9 Jul 1912 d. 29 Mar 1913
11
George Taft Benson, Jr
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.4]
b. 24 Jun 1875 d. 13 Aug 1934
Sarah Sophia Dunkley
b. 29 Jun 1878 d. 1 Jun 1933
12
Ezra Taft Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.4.1]
b. 4 Aug 1899 d. 30 May 1994 [
=>
]
12
Joseph Dunkley Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.4.2]
b. 12 Nov 1900 d. 24 Apr 1936 [
=>
]
12
Margaret Dunkley Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.4.3]
b. 16 Feb 1902 d. 3 Jul 1999 [
=>
]
12
Orval Dunkley Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.4.4]
b. 30 Aug 1903 d. 1 Jul 1991 [
=>
]
12
Louisa Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.4.5]
b. 10 Oct 1905 d. 2 Jul 1996 [
=>
]
12
Lera Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.4.6]
b. 4 May 1907 d. 10 Jun 2009 [
=>
]
12
Valdo Dunkley Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.4.7]
b. 23 Apr 1911 d. 30 Oct 1990 [
=>
]
12
George Taft Benson, III
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.4.8]
b. 27 Aug 1912 d. 15 Apr 1990 [
=>
]
12
Sarah Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.4.9]
b. 30 Sep 1914 d. 26 Sep 2001 [
=>
]
12
Ross Dean Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.4.10]
b. 20 Jan 1917 d. 23 Oct 1985
12
Volco Ballif Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.4.11]
b. 11 Apr 1920 d. 13 Mar 1992
+
Clara Maria Danielsen
b. 10 Feb 1892 d. 20 Oct 1958
11
Serge Ballif Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.5]
b. 2 Oct 1877 d. 18 Jan 1959
Melinda Caroline Nelson
b. 8 Sep 1881 d. 27 Jun 1971
12
Sergene Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.5.1]
b. 7 Aug 1904 d. 23 Jun 1995 [
=>
]
12
Serge Nelson Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.5.2]
b. 15 Mar 1906 d. 28 Oct 1994 [
=>
]
12
Constance Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.5.3]
b. 24 Apr 1908 d. 23 Jul 1981 [
=>
]
12
Donna Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.5.4]
b. 16 Mar 1910 d. 5 Dec 1997 [
=>
]
12
Fae Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.5.5]
b. 14 Feb 1914 d. 9 Oct 1968
12
Zetta Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.5.6]
b. 20 Aug 1916 d. 6 Sep 2013 [
=>
]
12
Theodore Nelson Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.5.7]
b. 1 Apr 1919 d. 27 Jan 2006 [
=>
]
12
Jacqueline Maurie Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.5.8]
b. 17 May 1925 d. 23 Apr 2019
11
Adeline Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.6]
b. 31 Jul 1879 d. 27 Jan 1960
Leo Peck
b. 28 Jun 1875 d. 12 Oct 1967
12
Florence Peck
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.6.1]
b. 1 May 1901 d. 23 Apr 1991 [
=>
]
12
Effie Peck
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.6.2]
b. 8 Feb 1903 d. 21 Jul 1992 [
=>
]
12
Leo Benson Peck
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.6.3]
b. 20 Jul 1905 d. 18 Nov 1917
12
Maurine Peck
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.6.4]
b. 22 Nov 1907 d. 4 Aug 1935 [
=>
]
12
Beth Peck
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.6.5]
b. 24 Sep 1912 d. 8 Sep 2000
12
Garth Benson Peck
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.6.6]
b. 18 Apr 1916 d. 14 Dec 1993
12
Olive Louise Peck
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.6.7]
b. 22 Jun 1920 d. 24 Aug 1993 [
=>
]
11
Florence Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.7]
b. 31 Jul 1879 d. 5 Nov 1967
Stanley Detlef Jonasson
b. 4 Mar 1878 d. 8 May 1959
12
Adeline Jonasson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.7.1]
b. 5 Nov 1906 d. 23 Jul 1975
12
Stanley Taft Jonasson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.7.2]
b. 29 Aug 1908 d. 9 Dec 1986
12
Helen Jonasson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.7.3]
b. 27 Sep 1910 d. 17 Oct 1931
12
Dorothy Jonasson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.7.4]
b. 1912 d. 1912
12
Alfred Benson ( Bill ) Jonasson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.7.5]
b. 26 Feb 1919 d. 16 Dec 2000
11
William Kennedy Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.8]
b. 9 Feb 1882 d. 28 Feb 1882
11
Frank Taft Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.9]
b. 23 Apr 1883 d. 19 Feb 1923
Elizabeth Greaves "Lillie" Eames
b. 6 Jun 1884 d. 28 Dec 1966
12
Gladys Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.9.1]
b. 12 Nov 1909 d. 27 Jan 1995 [
=>
]
12
Carmen Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.9.2]
b. 4 Nov 1911 d. 17 Aug 2001 [
=>
]
12
Harold Eames Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.9.3]
b. 4 Nov 1911 d. 20 Jul 1948 [
=>
]
12
Flora Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.9.4]
b. 30 Jan 1916 d. 14 Oct 1984 [
=>
]
12
Zenda Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.9.5]
b. 25 Oct 1918 d. 27 Feb 2003 [
=>
]
12
Frank Eames Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.9.6]
b. 26 Sep 1920 d. 2 Jan 1923
12
Nellie Louisa Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.9.7]
b. 11 Sep 1923 d. 11 Oct 1975 [
=>
]
11
Marie Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.10]
b. 19 Jul 1885 d. 6 Mar 1891
11
Carmen Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.11]
b. 7 Nov 1887 d. 5 Jul 1974
Franklin Brenneman Smith, Jr
b. Abt 1860 d. 11 Apr 1954
12
Franklin Breneman Smith, III
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.11.1]
b. 11 Jun 1923 d. 3 Apr 2009
12
Richard Benson Smith
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.11.2]
b. 15 Jun 1925 d. 8 Dec 2009
11
Jenny Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.12]
b. 30 Jun 1890 d. 12 Jul 1970
Earl Weaver
b. 22 Jun 1890 d. 11 Oct 1977
12
Kinnie Weaver
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.12.1]
b. 30 May 1916 d. 27 Aug 1999
12
Virginia Weaver
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.12.2]
b. 23 Dec 1917 d. 2012 [
=>
]
12
Mary Louise "Louie" Weaver
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.12.3]
b. 15 Jun 1921 d. 16 May 2012 [
=>
]
12
Earl Benson Weaver
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.12.4]
b. 27 Oct 1926 d. 1 Jan 2015 [
=>
]
12
Jenalee Weaver
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.12.5]
b. 1929 d. Aug 2015
11
Kathinka "Kinnie" Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.13]
b. 15 Mar 1894 d. 20 May 1960
Robert Sweeten Holbrook
b. 14 Oct 1893 d. 2 Jun 1980
12
Robert Benson Holbrook
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.13.1]
b. 5 Aug 1917 d. 29 Feb 2000 [
=>
]
12
George Benson Holbrook
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.13.2]
b. 3 Nov 1919 d. 7 Nov 2009 [
=>
]
12
Louise Holbrook
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.13.3]
b. 4 Jun 1912 d. 27 May 2009 [
=>
]
12
Donald Benson Holbrook
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.13.4]
b. 4 Feb 1925 d. 1 Mar 2005 [
=>
]
12
Gordon Benson Holbrook
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.10.13.5]
b. 22 Dec 1926 d. 2 Nov 1993 [
=>
]
10
Florence Adeline Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.11]
b. 17 Sep 1851 d. 25 Dec 1852
10
Nellie Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.12]
b. 30 Nov 1851 d. 24 Jan 1885
10
Frank Andrus Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.13]
b. 16 Oct 1853 d. 5 May 1937
Amanda Charlotta Eliason
b. 4 Jun 1861 d. 12 Mar 1922
11
Eva A Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.13.1]
b. 6 Jul 1882 d. 10 Aug 1946
11
Blanche Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.13.2]
b. 7 May 1888 d. 12 Sep 1979
11
Edna Mae Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.13.3]
b. 19 Oct 1890 d. 19 Mar 1976
11
Frank Andrus Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.13.4]
b. 30 Apr 1895 d. 18 Dec 1968
11
Eleanora Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.13.5]
b. 30 Nov 1896 d. 2 Oct 1992
11
Karl Eliason Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.13.6]
b. 21 Apr 1899 d. 21 Oct 1980
11
Adeline Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.13.7]
b. 14 Mar 1904 d. 5 May 1904
11
George Taft Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.13.8]
b. 17 Aug 1905 d. 18 Feb 1942
10
Samuel Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.14]
b. 1853
Eliza Ann Perry
b. 30 Mar 1828 d. 30 Apr 1913
10
Alice Eliza Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.15]
b. 11 Aug 1848 d. 3 Jun 1923
10
John Perry Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.16]
b. 24 Sep 1849 d. 4 Jan 1921
10
Malina Adelaide Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.17]
b. 21 Sep 1851 d. 31 Jul 1918
10
Orrin William Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.18]
b. 4 Oct 1853 d. 17 May 1917
10
Carrie Stella Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.19]
b. 22 May 1860 d. 15 Mar 1928
10
Abbie Della Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.20]
b. 16 Oct 1862 d. 22 Oct 1925
10
Grace Ann Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.21]
b. 31 Jan 1867 d. 15 Dec 1924
Elizabeth Gollaher
b. 30 Dec 1831 d. 4 May 1904
10
Fredrick Gollaher Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.22]
b. 17 Jan 1855 d. 6 Jan 1915
10
Brigham Young Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.23]
b. 17 Dec 1858 d. 11 Jul 1938
10
Luella Gollaher Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.24]
b. 12 Nov 1860 d. 22 Jul 1881
10
William C Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.25]
b. 11 Nov 1862 d. Sep 1937
10
Hyrum Smith Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.26]
b. 3 May 1864 d. 4 May 1935
10
Edith Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.27]
b. 22 Apr 1867 d. 11 Feb 1925
10
Lizzie Gollaher Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.28]
b. 9 Jul 1869 d. 30 Jul 1946
Olive Mary Knight
b. 24 Jan 1830 d. 27 Mar 1905
10
Louisa Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.29]
b. 29 Jun 1852 d. 29 Nov 1878
10
Heber Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.30]
b. Abt 1860 d. Bef 1868
10
Moroni Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.31]
b. 5 Nov 1861 d. 8 Jan 1934
10
Lorenzo Taft Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.32]
b. 3 Aug 1863 d. 6 Nov 1950
10
Joseph Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.33]
b. 13 Jul 1865 d. 5 Jun 1941
10
Ida May Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.34]
b. 16 Apr 1867 d. 30 Jun 1929
10
Don Carlos Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.35]
b. 29 Sep 1869 d. 19 Jan 1935
Mary Marie Larsen
b. 19 Dec 1843 d. 21 Feb 1926
10
Walter Taft Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.36]
b. 17 Jun 1867 d. 6 Jun 1957
10
Henry Taft Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.2.37]
b. 19 Mar 1869 d. 24 Feb 1947
+
Desdemona Wadsworth Fullmer
b. 6 Oct 1809 d. 9 Feb 1886
+
Lucinda Burton
b. 22 Oct 1825 d. 1 Oct 1863
9
George Taft Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.3]
b. Abt 1813
Prudence Maria Gifford
b. Abt 1815
10
Walter Everet Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.3.1]
b. 13 Sep 1857 d. 29 Apr 1907
Laura Frances Caldwell
b. 1862
11
Laura Livice Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.3.1.1]
b. 9 Oct 1883 d. 14 Feb 1911
Robert K Plummer
b. 1848 d. 21 Sep 1930
12
Gertude K Plummer
[1.1.5.1.5.5.7.1.3.1.1.1]
b. 1903
12
George K Plummer
[1.1.5.1.5.5.7.1.3.1.1.2]
b. 1904
12
Nathan B Plummer
[1.1.5.1.5.5.7.1.3.1.1.3]
b. 24 Jan 1911 d. 16 Nov 1994
11
George T Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.3.1.2]
b. Feb 1885
+
Ida N Steele
b. 9 Jan 1885
9
Hannah Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.4]
b. 18 Sep 1816
Henry Dodge
b. 15 Dec 1812 d. 22 Jun 1883
10
John M Dodge
[1.1.5.1.5.5.7.1.4.1]
b. 1838 d. 14 Feb 1898
10
Abbie R Dodge
[1.1.5.1.5.5.7.1.4.2]
b. 1850 d. 27 Sep 1916
John Averell
b. 1846 d. 19 Aug 1895
11
Elizabeth Alice Averell
[1.1.5.1.5.5.7.1.4.2.1]
b. 13 Apr 1884 d. 4 Feb 1901
+
William Cotter Ball
b. 1865
9
Abbie Ann Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.5]
b. Abt 1809 d. 21 Sep 1883
Calvin Rawson
b. 13 May 1797 d. 21 Jan 1868
10
Son Rawson
[1.1.5.1.5.5.7.1.5.1]
b. Abt 1828 d. Abt 1838
9
John M Benson
[1.1.5.1.5.5.7.1.6]
b. 1819 d. 12 Aug 1829
8
George Washington Benson
[1.1.5.1.5.5.7.2]
b. 25 May 1783 d. 10 Nov 1855
Alinda Warfield
b. 24 Aug 1785 d. 25 Apr 1841
9
Otis Benson
[1.1.5.1.5.5.7.2.1]
b. 28 Feb 1806 d. 16 Feb 1811
9
Harrison Benson
[1.1.5.1.5.5.7.2.2]
b. 10 Oct 1820 d. 25 Oct 1859
Marilla Adams
b. 12 Apr 1818 d. 16 Oct 1876
10
George Otis Benson
[1.1.5.1.5.5.7.2.2.1]
b. 24 Aug 1846 d. 2 May 1897
10
Reuben Benson
[1.1.5.1.5.5.7.2.2.2]
b. 1 Jan 1856 d. 25 Jul 1922
+
Marietta Ingraham Bliss
b. 27 Jun 1856 d. 21 Oct 1931
8
Jared Benson
[1.1.5.1.5.5.7.3]
b. 3 Feb 1785 d. 31 Jul 1854
Salley Taft
b. 21 Oct 1787 d. 7 Aug 1855
9
James Sulliven Benson
[1.1.5.1.5.5.7.3.1]
b. 19 Sep 1808 d. 3 Jan 1833
9
Putman Taft Benson
[1.1.5.1.5.5.7.3.2]
b. 28 Oct 1814 d. 24 Apr 1834
9
Jared Benson
[1.1.5.1.5.5.7.3.3]
b. 8 Nov 1821 d. 18 May 1894
Martha Taft
b. 23 Feb 1826 d. 19 Feb 1903
10
Sullivan Theodore Benson
[1.1.5.1.5.5.7.3.3.1]
b. 20 Apr 1844 d. 21 Sep 1911
10
Jared Irving Benson
[1.1.5.1.5.5.7.3.3.2]
b. 6 Oct 1846 d. 1919
Jenny Aiken Guild
b. 1852 d. 27 Oct 1906
11
Jared Curtis Benson
[1.1.5.1.5.5.7.3.3.2.1]
b. 6 Oct 1877
11
Frank Theodore Benson
[1.1.5.1.5.5.7.3.3.2.2]
b. 25 Feb 1878 d. Jul 1949
Ada Janette Foote
b. 5 Feb 1882 d. 10 Aug 1941
12
Donald Theodore Benson
[1.1.5.1.5.5.7.3.3.2.2.1]
b. 12 Jun 1903
12
Dorothy Martha Benson
[1.1.5.1.5.5.7.3.3.2.2.2]
b. 16 May 1904
12
Marjorie Emlyn Benson
[1.1.5.1.5.5.7.3.3.2.2.3]
b. 21 May 1906 d. 15 Feb 1977 [
=>
]
12
Eleanor Mae Benson
[1.1.5.1.5.5.7.3.3.2.2.4]
b. 7 Dec 1913 d. Apr 1980
10
Walter Bryant Benson
[1.1.5.1.5.5.7.3.3.3]
b. 16 Jan 1850 d. 10 Feb 1860
10
Grace Sally Benson
[1.1.5.1.5.5.7.3.3.4]
b. 2 Sep 1852 d. 25 Feb 1863
9
Sylvanus Holbrook Benson
[1.1.5.1.5.5.7.3.4]
b. 23 Jun 1828 d. 1878
Laurett V Howard
b. 1830 d. 1860
10
Ellen Laura Benson
[1.1.5.1.5.5.7.3.4.1]
b. 18 Aug 1851
George Hawes Lapham
b. 12 Jul 1849
11
Hattie Cobb Lapham
[1.1.5.1.5.5.7.3.4.1.1]
b. 21 Oct 1873 d. 13 Jun 1906
11
Albert Francis Lapham
[1.1.5.1.5.5.7.3.4.1.2]
b. 11 Dec 1876
Ida Luella Bradshaw
b. Abt 1881
12
Beatrice Fairbanks Lapham
[1.1.5.1.5.5.7.3.4.1.2.1]
b. 5 Jul 1904
12
Louise Frances Lapham
[1.1.5.1.5.5.7.3.4.1.2.2]
b. 4 Jun 1909
11
Frank Atwood Lapham
[1.1.5.1.5.5.7.3.4.1.3]
b. 2 Oct 1878
11
Frederick Lapham
[1.1.5.1.5.5.7.3.4.1.4]
b. 2 Sep 1880
11
Daughter Lapham
[1.1.5.1.5.5.7.3.4.1.5]
b. 19 Nov 1882
11
William Lapham
[1.1.5.1.5.5.7.3.4.1.6]
b. 29 Apr 1884 d. Bef 1890
11
Teresa Lapham
[1.1.5.1.5.5.7.3.4.1.7]
b. 10 Dec 1886
11
William Lapham
[1.1.5.1.5.5.7.3.4.1.8]
b. 5 Nov 1890 d. 24 May 1898
10
Ernest S Benson
[1.1.5.1.5.5.7.3.4.2]
b. 25 May 1855
+
Ida Cornelia Furbish
b. 1858
10
Laurett Victoria Howard Benson
[1.1.5.1.5.5.7.3.4.3]
b. 1859 d. 3 Jul 1883
Ezra Hunt Bailey
b. 23 Dec 1853 d. 3 May 1929
11
Edith L Bailey
[1.1.5.1.5.5.7.3.4.3.1]
b. 19 Jan 1881 d. 1962
+
Frederick Herbert
b. 29 Apr 1874
Lottie E. Kelly
10
Lottie E. Benson
[1.1.5.1.5.5.7.3.4.4]
b. 20 Sep 1866
8
Abigail Benson
[1.1.5.1.5.5.7.4]
b. 13 Feb 1787
Putman Taft
b. 5 Aug 1783 d. 20 Feb 1810
9
Mary Ann Taft
[1.1.5.1.5.5.7.4.1]
b. 23 Oct 1807
+
Samuel T Holroyd
b. 1791 d. 4 Nov 1817
+
Angel Sweet
b. 7 Apr 1790 d. 28 Apr 1825
+
Edward Ide Bower
+
Joseph McDermott
8
Mary "Polly" Benson
[1.1.5.1.5.5.7.5]
b. 9 Jun 1788 d. 12 Jan 1864
Bailey Legg
b. 9 May 1783 d. 11 Oct 1862
9
Sylvanus B Legg
[1.1.5.1.5.5.7.5.1]
b. 20 Jun 1813 d. Bef 8 Jun 1885
9
Mary H Legg
[1.1.5.1.5.5.7.5.2]
b. 7 Jul 1815
9
Harriet H Legg
[1.1.5.1.5.5.7.5.3]
b. 14 Jun 1817
8
Phyba Benson
[1.1.5.1.5.5.7.6]
b. Abt 1790
8
Prudence Benson
[1.1.5.1.5.5.7.7]
b. 7 Jul 1795
8
Thankful Benson
[1.1.5.1.5.5.7.8]
b. 26 Nov 1799 d. 1 May 1852
Joseph Bartlett Cook
b. 3 Dec 1796 d. 6 Oct 1856
9
William Walker Cook
[1.1.5.1.5.5.7.8.1]
b. 21 Mar 1820
Nancy Marion Draper
b. 17 Mar 1823
10
Edwin L Cook
[1.1.5.1.5.5.7.8.1.1]
b. 29 Mar 1857
+
Elisabeth M Campbell
b. Abt 1848
9
Amanda Melvina Cook
[1.1.5.1.5.5.7.8.2]
b. 12 Oct 1821
9
Mary Adeliza Cook
[1.1.5.1.5.5.7.8.3]
b. 18 Apr 1824
9
Emily Caroline Cook
[1.1.5.1.5.5.7.8.4]
b. 8 Feb 1826 d. 7 Mar 1826
9
Elma Ann Cook
[1.1.5.1.5.5.7.8.5]
b. 29 Jan 1827 d. 13 Jan 1870
William Gibbs Comstock
b. 3 Feb 1827 d. 29 Apr 1914
10
Alice Ardella Comstock
[1.1.5.1.5.5.7.8.5.1]
b. 10 Dec 1850 d. 20 Sep 1914
Sandford Phipps
b. 25 Aug 1850 d. 1919
11
Ross Elliot Phipps
[1.1.5.1.5.5.7.8.5.1.1]
b. 3 Sep 1877 d. 31 May 1958
Elouise G Gibbs
b. 2 Jul 1884 d. 10 Sep 1960
12
Nelson Sanford Phipps
[1.1.5.1.5.5.7.8.5.1.1.1]
b. 29 Dec 1912 d. 20 Mar 2003
12
Ross E Phipps
[1.1.5.1.5.5.7.8.5.1.1.2]
b. 18 Jun 1915 d. 26 May 1999 [
=>
]
11
Edith Ardella Phipps
[1.1.5.1.5.5.7.8.5.1.2]
b. 12 Sep 1879
+
Irvin Grover Lincoln
b. 30 Aug 1888
11
George Curtis Phipps
[1.1.5.1.5.5.7.8.5.1.3]
b. 25 Feb 1882 d. 4 Aug 1962
+
Anna Violet Sharp
b. 1887
10
Fanny Amanda Comstock
[1.1.5.1.5.5.7.8.5.2]
b. 4 Jul 1854 d. 2 Sep 1934
8
Sulvanus Holbrook Benson
[1.1.5.1.5.5.7.9]
b. 12 Jan 1797 d. 24 Aug 1812
8
Judson Benson
[1.1.5.1.5.5.7.10]
b. Abt 1801 d. 15 Oct 1813
7
Stephen Holbrook
[1.1.5.1.5.5.8]
b. 19 Jun 1764 d. 16 Aug 1830
Hope Albee
b. Abt 1765 d. 18 Jan 1840
8
Rachel Holbrook
[1.1.5.1.5.5.8.1]
b. 22 Apr 1789
8
Sylvanus Holbrook
[1.1.5.1.5.5.8.2]
b. 28 Jul 1792 d. 9 Dec 1855
8
Willard Holbrook
[1.1.5.1.5.5.8.3]
b. 7 Apr 1795 d. 4 Mar 1862
8
Wilder Holbrook
[1.1.5.1.5.5.8.4]
b. 7 Apr 1795 d. 2 Jan 1855
8
Chloe Holbrook
[1.1.5.1.5.5.8.5]
b. 13 Aug 1801 d. 11 Aug 1855
8
Henry Holbrook
[1.1.5.1.5.5.8.6]
b. 19 Apr 1804 d. 10 Jul 1874
8
Ellery Holbrook
[1.1.5.1.5.5.8.7]
b. 26 Jun 1810 d. 10 Jul 1847
7
Abigail Holbrook
[1.1.5.1.5.5.9]
b. 13 Sep 1765
7
Henry Holbrook
[1.1.5.1.5.5.10]
b. 11 Feb 1768 d. 18 Dec 1868
+
Barbara Thayer
b. 27 Feb 1770
7
Lucy Holbrook
[1.1.5.1.5.5.11]
b. 13 Sep 1770 d. 29 Jan 1843
Abner Adams
b. 4 Nov 1757 d. Aft 1831
8
Silvanus Adams
[1.1.5.1.5.5.11.1]
b. 7 Oct 1796 d. 6 Feb 1872
8
Washington Adams
[1.1.5.1.5.5.11.2]
b. 11 Dec 1799
8
Ruth Adams
[1.1.5.1.5.5.11.3]
b. 11 May 1802
8
Harriet Thayer Adams
[1.1.5.1.5.5.11.4]
b. 8 Oct 1804 d. 29 Oct 1825
8
Abner Adams
[1.1.5.1.5.5.11.5]
b. 11 Feb 1806
8
Judson Adams
[1.1.5.1.5.5.11.6]
b. 23 Mar 1808 d. 1843
8
Washington Adams
[1.1.5.1.5.5.11.7]
b. 1810
8
Zebediah Adams
[1.1.5.1.5.5.11.8]
b. 3 Aug 1814 d. 3 Apr 1815
6
Comfort Thayer
[1.1.5.1.5.6]
b. 28 Jul 1728 bur. 17 Oct 1761
+
Samuel Fish
b. Abt 1728
6
Margaret Thayer
[1.1.5.1.5.7]
b. 20 Mar 1730
Jonathan Farnham
b. 21 Apr 1739 d. 4 Mar 1816
7
Oliver Farnham
[1.1.5.1.5.7.1]
b. Dec 1753
6
Susanna Thayer
[1.1.5.1.5.8]
b. 14 Sep 1731
Elisha Hale
b. 11 Jan 1728 d. 6 Oct 1809
7
James Hale
[1.1.5.1.5.8.1]
b. 16 Feb 1753
7
Simeon Hale
[1.1.5.1.5.8.2]
b. 6 Mar 1756
6
Stephen Thayer
[1.1.5.1.5.9]
b. 26 Sep 1733
Rachel Davis
b. 29 Dec 1741 d. 14 Jan 1816
7
Philidelphia Thayer
[1.1.5.1.5.9.1]
b. 10 Nov 1763 d. 1843
7
Phylidelphia Thayer
[1.1.5.1.5.9.2]
b. 10 Nov 1763 d. 1843
7
Nathan Thayer
[1.1.5.1.5.9.3]
b. 22 Dec 1763 d. 1 May 1812
7
Stephen Thayer
[1.1.5.1.5.9.4]
b. 14 Mar 1765 d. 3 Mar 1819
7
Rachel Thayer
[1.1.5.1.5.9.5]
b. 1769
7
Nancy Thayer
[1.1.5.1.5.9.6]
b. 24 May 1771 d. 27 May 1822
7
Limon Alanson Thayer
[1.1.5.1.5.9.7]
b. 1772
7
Dolinda Thayer
[1.1.5.1.5.9.8]
b. 13 Apr 1774
7
Nahum Thayer
[1.1.5.1.5.9.9]
b. Abt 1776 d. 1811
7
Windsor Thayer
[1.1.5.1.5.9.10]
b. 21 Jun 1778
7
Aaron Chance Thayer
[1.1.5.1.5.9.11]
b. 29 Jan 1780 d. 27 Jul 1856
7
Lucinda Thayer
[1.1.5.1.5.9.12]
b. 1 Jan 1782 d. 5 Nov 1828
6
Olive Thayer
[1.1.5.1.5.10]
b. Abt 1735
+
Farnum
b. Abt 1731 d. Abt 1757
5
Elizabeth Sampson
[1.1.5.1.6]
b. Abt 1696 d. 17 Apr 1744
5
Dorcas Sampson
[1.1.5.1.7]
b. Abt 1698
5
Abigail Sampson
[1.1.5.1.8]
b. Abt 1700
4
Desire Sprague
[1.1.5.2]
b. Abt 1668
3
Joseph Bassett
[1.1.6]
b. 1635 d. 2 Oct 1712
2
Thomas Tilden
[1.2]
c. 23 Oct 1608 d. 19 Jan 1618
2
Mary Tilden
[1.3]
b. 20 May 1610 d. 28 Mar 1690
2
Joseph Tilden
[1.4]
b. 12 Jan 1612 d. 3 Jun 1670
2
Sarah Tilden
[1.5]
b. 13 Jun 1613 d. 20 Mar 1677
2
Stephen Tilden
[1.6]
b. 13 Mar 1617 d. 21 Oct 1619
2
Thomas Tilden
[1.7]
b. 19 Jan 1618 d. 1 Feb 1704
Elizabeth Bourne
b. Abt 1618 d. 12 Dec 1663
3
Thomas Tilden
[1.7.1]
b. 25 Jun 1654 bur. 29 Jun 1654
3
Son Tilden
[1.7.2]
b. 4 Oct 1655 bur. 5 Oct 1655
3
Elizabeth Tilden
[1.7.3]
b. Abt 1656
3
Lydia Tilden
[1.7.4]
b. 26 Apr 1658 d. 17 Sep 1740
3
Rebecca Tilden
[1.7.5]
b. 12 Dec 1663
Mary Holmes
b. Abt 1644 d. Aft 1705
3
Mary Tilden
[1.7.6]
b. 14 Feb 1663 d. 13 Jan 1731
Anthony Sprague, Jr
b. 18 Aug 1663 d. Aft 13 May 1731
4
Anthony Sprague
[1.7.6.1]
b. 16 Jun 1690 d. 7 Feb 1745
4
Benjamin Sprague
[1.7.6.2]
b. 7 Sep 1691 d. 1 Jan 1692
4
Mary Sprague
[1.7.6.3]
b. 1 Oct 1692 d. 26 Jul 1784
Eleazar Whipple, Jr
b. Abt 1672 d. 17 Dec 1734
5
Eleazer Whipple
[1.7.6.3.1]
b. 1720 d. 2 Mar 1733
4
Elizabeth Sprague
[1.7.6.4]
b. 26 May 1695 d. 2 May 1735
Captain William Whipple, Jr
b. Abt 1691 d. 16 Nov 1776
5
Mary Whipple
[1.7.6.4.1]
b. 28 Feb 1714 d. 1755
Stephen Olney
b. 25 Aug 1717 d. 4 Nov 1754
6
Benjamin Oney
[1.7.6.4.1.1]
b. 1735 d. Aug 1801
6
Mary Jemima Olney
[1.7.6.4.1.2]
b. Abt 1738 d. Abt 1820
6
Sarah Olney
[1.7.6.4.1.3]
b. 1742 d. 24 Apr 1815
6
James Olney
[1.7.6.4.1.4]
b. 9 Feb 1743
6
Stephen Olney, Jr
[1.7.6.4.1.5]
b. 22 Dec 1752 d. 12 Dec 1841
5
Elizabeth Whipple
[1.7.6.4.2]
b. 26 May 1716 d. Bef 24 Oct 1718
5
Jemima Whipple
[1.7.6.4.3]
b. 4 Oct 1717
+
Benjamin Davis
5
Elizabeth Amy Whipple
[1.7.6.4.4]
b. 24 Oct 1718 d. 1764
Jeremiah Wilkinson
b. 4 Jun 1707 d. 23 Mar 1792
6
William Wilkinson
[1.7.6.4.4.1]
b. 31 Jul 1739 d. 1 Jul 1814
Molly Alverson
b. 1 Sep 1738 d. 17 Mar 1814
7
William Wilkinson
[1.7.6.4.4.1.1]
b. 1763
7
George Wilkinson
[1.7.6.4.4.1.2]
b. 16 Jun 1765 d. 4 Jan 1855
7
David Wilkinson
[1.7.6.4.4.1.3]
7
Christopher Wilkinson
[1.7.6.4.4.1.4]
b. 28 Jul 1768 d. 5 Feb 1854
7
John Wilkinson
[1.7.6.4.4.1.5]
7
Ruth Wilkinson
[1.7.6.4.4.1.6]
7
Mollie Wilkinson
[1.7.6.4.4.1.7]
7
Hannah Wilkinson
[1.7.6.4.4.1.8]
7
Simon Wilkinson
[1.7.6.4.4.1.9]
b. 1780 d. 1861
7
Freelove Wilkinson
[1.7.6.4.4.1.10]
7
Amey Wilkinson
[1.7.6.4.4.1.11]
6
Jeremiah Wilkinson
[1.7.6.4.4.2]
b. 6 Jul 1741 d. 29 Jan 1831
Hope Mosher
b. 17 Feb 1751 d. 3 Feb 1774
7
Anna Wilkenson
[1.7.6.4.4.2.1]
b. 10 Mar 1768 d. 26 Feb 1849
7
Gardner Wilkinson
[1.7.6.4.4.2.2]
b. 28 May 1769 d. 24 May 1852
7
Jeremiah Wilkinson
[1.7.6.4.4.2.3]
b. 25 Jan 1771 d. 23 May 1812
7
Jonathan Wilkinson
[1.7.6.4.4.2.4]
b. 22 Feb 1772 d. 30 Nov 1808
7
Job Wilkinson
[1.7.6.4.4.2.5]
b. 21 Jan 1774 d. 1 May 1836
Elizabeth Southwick
b. 29 Mar 1746 d. 1804
7
Ruth Wilkinson
[1.7.6.4.4.2.6]
b. 26 Feb 1779 d. 11 Feb 1814
7
Elizabeth Wilkinson
[1.7.6.4.4.2.7]
b. 8 Mar 1781 d. 24 Dec 1783
7
Daniel Wilkinson
[1.7.6.4.4.2.8]
b. 3 Jan 1783 d. 18 Jul 1865
7
Judith Wilkinson
[1.7.6.4.4.2.9]
b. 29 May 1785 d. 1 May 1866
7
Lydia Wilkinson
[1.7.6.4.4.2.10]
b. 27 Sep 1786
7
James Wilkinson
[1.7.6.4.4.2.11]
b. 8 Oct 1788 d. 19 Jul 1862
6
Simon Wilkinson
[1.7.6.4.4.3]
b. 24 Sep 1743 d. 7 Jul 1819
Hannah Whipple
b. 15 Jun 1741 d. 1835
7
Vienna Wilkinson
[1.7.6.4.4.3.1]
b. 18 Nov 1768 d. 1829
7
Lucina Wilkinson
[1.7.6.4.4.3.2]
b. 26 May 1771 d. 1829
7
Hannah Wilkinson
[1.7.6.4.4.3.3]
b. 17 Aug 1777 d. 21 Mar 1778
7
Hannah Wilkinson
[1.7.6.4.4.3.4]
b. 16 Oct 1782 d. 5 Nov 1831
6
Benjamin Wilkinson
[1.7.6.4.4.4]
b. 1 Nov 1745 d. 25 Mar 1818
Hannah Staples
b. 30 Apr 1745 d. 1835
7
Amey Wilkinson
[1.7.6.4.4.4.1]
b. 26 Oct 1770 d. 4 Apr 1859
7
Benjamin Wilkinson
[1.7.6.4.4.4.2]
b. 8 May 1772 d. 3 Nov 1772
7
Welcome Wilkinson
[1.7.6.4.4.4.3]
b. 10 Dec 1773 d. 20 Jun 1795
7
Vernum Wilkinson
[1.7.6.4.4.4.4]
b. 1775
7
Russel Wilkinson
[1.7.6.4.4.4.5]
b. 1777
7
Cynthia Wilkinson
[1.7.6.4.4.4.6]
b. 1779
7
Benjamin Green Wilkinson
[1.7.6.4.4.4.7]
b. 1781 d. 11 Jul 1806
6
Patience Wilkinson
[1.7.6.4.4.5]
b. 20 Mar 1747 d. 19 Apr 1819
Thomas Hazard Potter
b. 8 Dec 1753 d. 11 Sep 1807
7
John Potter
[1.7.6.4.4.5.1]
b. 1772 d. 11 Aug 1854
7
Susan Potter
[1.7.6.4.4.5.2]
b. 1774
7
Eliza Potter
[1.7.6.4.4.5.3]
b. 16 Nov 1785 d. 28 Aug 1829
6
Amy Wilkinson
[1.7.6.4.4.6]
b. 20 Mar 1747 d. Aft 12 Feb 1817
Peter Darling
b. Aft 1725 d. 16 May 1818
7
Elijah Darling
[1.7.6.4.4.6.1]
b. 7 Oct 1773 d. 14 Apr 1846
7
Benjamin Darling
[1.7.6.4.4.6.2]
b. 23 Jul 1774 d. Aft 12 Feb 1817
7
Johanna Darling
[1.7.6.4.4.6.3]
b. 3 Jan 1776 d. 1841
7
Reuben Darling
[1.7.6.4.4.6.4]
b. Abt 1780 d. 4 Jul 1869
7
Welcome B Darling
[1.7.6.4.4.6.5]
b. Abt 1783 d. 23 Mar 1853
Sarah Leocia Olney
b. Abt 1803 d. 9 Feb 1883
8
William Olney Darling
[1.7.6.4.4.6.5.1]
b. 1825 d. 10 Dec 1854
8
Samuel B Darling
[1.7.6.4.4.6.5.2]
b. Abt 1828
Francis Arnold Irons
b. 6 May 1828 d. 13 Nov 1913
9
Susan S Darling
[1.7.6.4.4.6.5.2.1]
b. 23 Jun 1854
8
Anna Frances Darling
[1.7.6.4.4.6.5.3]
b. 1835 d. 3 Sep 1914
William Stone
b. 1833 d. 15 Oct 1888
9
Ella J Stone
[1.7.6.4.4.6.5.3.1]
b. Apr 1855
9
William Darling Stone
[1.7.6.4.4.6.5.3.2]
b. 15 Sep 1872
8
Sarah Emily Darling
[1.7.6.4.4.6.5.4]
b. Jul 1837
Charles Olney Ballou
b. 10 Jun 1830
9
Edith P Ballou
[1.7.6.4.4.6.5.4.1]
b. 14 Jun 1862 d. 14 Jun 1864
9
Anna Darling Ballou
[1.7.6.4.4.6.5.4.2]
b. 22 Mar 1865
9
Kate Stewart Ballou
[1.7.6.4.4.6.5.4.3]
b. 9 Sep 1866 d. 1926
William George Payton
b. 11 Aug 1867 d. 11 May 1954
10
Ralph Ballou Payton
[1.7.6.4.4.6.5.4.3.1]
b. 21 Jul 1892
8
Welcome Ballou Darling
[1.7.6.4.4.6.5.5]
b. Abt 1841
+
Sarah K Emerson
b. Abt 1845
7
Jeptha Darling
[1.7.6.4.4.6.6]
6
Marcy Wilkinson
[1.7.6.4.4.7]
b. 14 Aug 1750 d. 1830
+
William Aldrich
b. 19 Jun 1760 d. 15 May 1852
6
Jemima Wilkinson
[1.7.6.4.4.8]
b. 29 Nov 1752 d. 1 Jul 1819
6
Stephen Wilkinson
[1.7.6.4.4.9]
b. 29 Jan 1755 d. 1821
Elizabeth Sheldon
b. 1759
7
Sally Wilkinson
[1.7.6.4.4.9.1]
b. 17 Oct 1792
7
Preston Wilkinson
[1.7.6.4.4.9.2]
b. 1793
7
Manning Wilkinson
[1.7.6.4.4.9.3]
b. 1795
7
Leonard Wilkinson
[1.7.6.4.4.9.4]
b. 1797
7
Rufus Wilkinson
[1.7.6.4.4.9.5]
b. 16 Feb 1798
7
Lewis Wilkinson
[1.7.6.4.4.9.6]
b. 8 Aug 1800
7
Barton Brenton Wilkinson
[1.7.6.4.4.9.7]
b. 22 Apr 1802
6
Jeptha Wilkinson
[1.7.6.4.4.10]
b. 3 Apr 1757 d. 15 Aug 1803
Lucy Smith
b. 1760 d. 11 Feb 1823
7
Alpha Wilkinson
[1.7.6.4.4.10.1]
b. 12 Oct 1784 d. 12 Feb 1857
7
Nancy Wilkinson
[1.7.6.4.4.10.2]
b. 18 Jan 1786 d. Aft 1869
7
Arnold Wilkinson
[1.7.6.4.4.10.3]
b. 25 May 1787
7
Ransom Wilkinson
[1.7.6.4.4.10.4]
b. 4 Mar 1789 d. 4 Mar 1789
7
Jeptha Avery Wilkinson
[1.7.6.4.4.10.5]
b. 23 Apr 1791
7
Lucy Wilkinson
[1.7.6.4.4.10.6]
b. 11 Aug 1792
7
Mary Ann Wilkinson
[1.7.6.4.4.10.7]
b. 23 Sep 1793
7
Abigail Amy Wilkinson
[1.7.6.4.4.10.8]
b. 4 Jun 1798
6
Elizabeth Wilkinson
[1.7.6.4.4.11]
b. 6 Dec 1760 d. 1850
Samuel Hartwell
b. 13 Apr 1760 d. 1851
7
Bennoni Wilkinson
[1.7.6.4.4.11.1]
b. 2 Mar 1782 d. 11 Feb 1864
7
Samuel Hartwell
[1.7.6.4.4.11.2]
b. 31 Jul 1783
7
Elizabeth Hartwell
[1.7.6.4.4.11.3]
b. 30 Dec 1787 d. 18 Jun 1849
7
Amey Hartwell
[1.7.6.4.4.11.4]
b. 27 Feb 1789
7
Stephen Hartwell
[1.7.6.4.4.11.5]
b. 19 Feb 1792
7
Joseph Hartwell
[1.7.6.4.4.11.6]
b. 28 Mar 1793
7
Elijah Hartwell
[1.7.6.4.4.11.7]
b. 31 Mar 1794
7
Mercy Hartwell
[1.7.6.4.4.11.8]
b. 12 May 1796
7
Moses Hartwell
[1.7.6.4.4.11.9]
b. 5 May 1798
7
Aaron Hartwell
[1.7.6.4.4.11.10]
b. 22 Mar 1800
6
Deborah Wilkinson
[1.7.6.4.4.12]
b. 28 Aug 1764 d. 15 Apr 1850
+
Benjamin Botsford
b. 1760 d. 11 Sep 1802
5
William Whipple
[1.7.6.4.5]
b. 1 Nov 1719 d. 16 Nov 1796
5
Mercy Whipple
[1.7.6.4.6]
b. 15 Mar 1721
David Arnold
b. Abt 1710 d. 1 Feb 1786
6
Elisha Arnold
[1.7.6.4.6.1]
b. 1754 d. 27 May 1838
6
Stephen Arnold
[1.7.6.4.6.2]
b. Aft 1756
6
David Arnold
[1.7.6.4.6.3]
6
Eleazer Aldrich
[1.7.6.4.6.4]
6
Abigail Arnold
[1.7.6.4.6.5]
6
Martha Arnold
[1.7.6.4.6.6]
5
Jeremiah Whipple
[1.7.6.4.7]
b. 19 May 1722 d. 1722
5
Hopestill Whipple
[1.7.6.4.8]
b. 28 May 1723 d. 12 Oct 1793
Nicholas Brown
b. 24 Feb 1721 d. 12 Oct 1793
6
Ichabod Brown
[1.7.6.4.8.1]
b. Abt 1745 d. 16 Sep 1828
6
Lieutenant Jeremiah Brown
[1.7.6.4.8.2]
b. 1747 d. 1796
6
Nicholas Brown
[1.7.6.4.8.3]
b. 22 Dec 1749 d. 21 Jul 1833
6
Levi Brown
[1.7.6.4.8.4]
b. 3 Aug 1752 d. 1823
6
Mary Brown
[1.7.6.4.8.5]
b. 1753
6
Elizabeth "Betty" Brown
[1.7.6.4.8.6]
b. 10 Jan 1754 d. 1842
6
Hopestill Brown
[1.7.6.4.8.7]
b. 1757 d. 13 Apr 1800
6
Abiel Brown
[1.7.6.4.8.8]
b. 1760
5
John Whipple
[1.7.6.4.9]
b. 7 May 1724 d. 20 Mar 1807
5
Anthony Whipple
[1.7.6.4.10]
b. 9 Apr 1725 d. 11 Jul 1751
5
Sarah Whipple
[1.7.6.4.11]
b. 10 Oct 1726
Noah Aldrich
b. 3 Dec 1709 d. 28 Aug 1808
6
Solomon Aldrich
[1.7.6.4.11.1]
b. 1755
5
Benjamin Whipple
[1.7.6.4.12]
b. 3 Jun 1728 d. 12 Jun 1812
Jerusha Peck
b. 11 Feb 1741 d. 20 May 1766
6
Jeremiah Whipple
[1.7.6.4.12.1]
b. 1760 d. 6 Aug 1830
Amy Sprague
b. 19 Dec 1762 d. 6 Aug 1831
7
Jerusha or Rushia Whipple
[1.7.6.4.12.1.1]
b. Abt 1786 d. 10 Jun 1853
7
Libbens Whipple
[1.7.6.4.12.1.2]
b. 7 Aug 1790 d. 16 Aug 1869
7
Arthur Whipple
[1.7.6.4.12.1.3]
b. 30 Nov 1793 d. 17 Dec 1853
Elizabeth Arnold
b. 1 Jan 1808 d. 11 Feb 1898
8
Amanda Whipple
[1.7.6.4.12.1.3.1]
b. 17 Nov 1829 d. 17 Dec 1832
8
John Whipple
[1.7.6.4.12.1.3.2]
b. Abt 1834 d. 26 Oct 1834
8
Amey Ann Whipple
[1.7.6.4.12.1.3.3]
b. Sep 1836 d. Aft Apr 1910
Benjamin Phetteplace
b. 1848
9
Annie E Phetteplace
[1.7.6.4.12.1.3.3.1]
b. Abt 1859
9
Laura M Phetteplace
[1.7.6.4.12.1.3.3.2]
b. 1861 d. 16 May 1937
+
Daniel Loynds
b. 28 Mar 1861
9
Sarah Whipple Phetteplace
[1.7.6.4.12.1.3.3.3]
b. Abt 1864 d. 19 Nov 1919
Winfield Dextor Smith
b. Abt 1861 d. 3 Nov 1939
10
Frank Stearns Smith
[1.7.6.4.12.1.3.3.3.1]
b. 24 Sep 1888 d. 25 May 1945
+
Gertrude Hamilton
10
Alison Parkhurst Smith
[1.7.6.4.12.1.3.3.3.2]
b. Abt 1890 d. 19 Jan 1937
9
Benjamin Lester Phetteplace
[1.7.6.4.12.1.3.3.4]
b. Apr 1866 d. 8 Nov 1938
Susan Squires
10
Benjamin Squire Phetteplace
[1.7.6.4.12.1.3.3.4.1]
b. 24 Nov 1894 d. Aft 1930
Elizabeth
b. Abt 1892 d. Aft 1930
11
Elizabeth T Phetteplace
[1.7.6.4.12.1.3.3.4.1.1]
11
Patricia Ann Phetteplace
[1.7.6.4.12.1.3.3.4.1.2]
10
Wesley Merritt Phetteplace
[1.7.6.4.12.1.3.3.4.2]
b. 11 Jun 1898 d. 10 Feb 1977
+
Hazel M Estey
b. 26 Sep 1893 d. 17 Aug 1975
8
Jeremiah Whipple
[1.7.6.4.12.1.3.4]
b. 1840 d. 18 Jul 1866
+
Eliza Minerva Whipple
b. 25 Dec 1831 d. 21 Jan 1926
8
Phebe Whipple
[1.7.6.4.12.1.3.5]
b. 18 Aug 1841 d. 6 Apr 1930
John Kay Dexter
b. Abt 1838 d. 22 Apr 1915
9
John Dexter
[1.7.6.4.12.1.3.5.1]
b. 11 Jun 1863 d. 24 Oct 1927
Grace Eveline Huling
b. 17 Aug 1858 d. 31 Dec 1941
10
Carrol Huling Dexter
[1.7.6.4.12.1.3.5.1.1]
b. 8 Oct 1893 d. 6 Oct 1948
9
Frederick Everett Dexter
[1.7.6.4.12.1.3.5.2]
b. 21 Jun 1869 d. 11 Dec 1949
James Newell Phetteplace
b. Jul 1837 d. 1 Aug 1908
9
Morton Phetteplace
[1.7.6.4.12.1.3.5.3]
b. 25 Dec 1879 d. Aft 1942
Mary Evelyn Harris
b. 1 Nov 1880 d. 15 Jul 1933
10
George Morton Phetteplace
[1.7.6.4.12.1.3.5.3.1]
b. Abt 1905 d. 16 Jan 1912
10
Helen A Phetteplace
[1.7.6.4.12.1.3.5.3.2]
b. 13 Aug 1907 d. Jan 1994
10
James Burton Phetteplace
[1.7.6.4.12.1.3.5.3.3]
b. 20 Sep 1909 d. Feb 1985
10
Alice E Phetteplace
[1.7.6.4.12.1.3.5.3.4]
b. 1 Sep 1910 d. 24 Sep 1990
9
Sarah Evelyn Phetteplace
[1.7.6.4.12.1.3.5.4]
b. 17 Jun 1882
8
Laura Jane Whipple
[1.7.6.4.12.1.3.6]
b. 1844 d. 21 Dec 1936
Thomas Leferga Jollie
b. 1843 d. 8 Dec 1911
9
Laura Etta Jollie
[1.7.6.4.12.1.3.6.1]
b. 17 Jun 1877
9
Mary E "Mame" Jollie
[1.7.6.4.12.1.3.6.2]
9
Nellie Augusta "Nell" Jollie
[1.7.6.4.12.1.3.6.3]
b. Abt 1868
Walter Bert Gardiner
b. Abt 1868
10
Milton Warren Gardner
[1.7.6.4.12.1.3.6.3.1]
b. 3 Nov 1897 d. 22 May 1988
+
Florence Etta Anderton
b. 6 Jun 1897 d. 3 May 1984
9
Isabel Dora Jollie
[1.7.6.4.12.1.3.6.4]
b. 21 Sep 1872 d. 14 Apr 1972
9
Fred L Jollie
[1.7.6.4.12.1.3.6.5]
9
Ettie E Jollie
[1.7.6.4.12.1.3.6.6]
9
Eva May Jollie
[1.7.6.4.12.1.3.6.7]
b. 14 Apr 1880
8
Eliza Emma Whipple
[1.7.6.4.12.1.3.7]
b. 26 Feb 1846 d. 21 Nov 1901
Charles Joseph Northup
b. 16 Mar 1846 d. 22 Oct 1917
9
Daniel Anthony Northup
[1.7.6.4.12.1.3.7.1]
b. 17 Jan 1867 d. 4 Jan 1935
Annis Brown
b. 19 Aug 1870 d. 1951
10
Charlotte Northup
[1.7.6.4.12.1.3.7.1.1]
b. 28 Jul 1877 d. 18 Aug 1878
10
Charles Henry Northup
[1.7.6.4.12.1.3.7.1.2]
b. 16 Sep 1894 d. 20 Feb 1963
Bertha Oldfield
b. 28 Jan 1892 d. 21 Mar 1936
11
Dorcas Annis Northup
[1.7.6.4.12.1.3.7.1.2.1]
b. 17 Nov 1922 d. 8 Feb 1986
11
Charles Henry Northup
[1.7.6.4.12.1.3.7.1.2.2]
b. 11 Feb 1924 d. 13 Dec 1997
10
Living
[1.7.6.4.12.1.3.7.1.3]
9
Eunice Mabell Northup
[1.7.6.4.12.1.3.7.2]
b. 24 Oct 1874 d. 15 Jul 1875
9
Elizabeth Ellen Northup
[1.7.6.4.12.1.3.7.3]
b. 11 Dec 1880 d. 22 Jan 1956
Edgar Franklin Curtis
b. 4 Feb 1878 d. 6 Nov 1947
10
Earl Myron Curtis
[1.7.6.4.12.1.3.7.3.1]
10
Walter Benjamin Curtis
[1.7.6.4.12.1.3.7.3.2]
10
Esther Lillian Curtis
[1.7.6.4.12.1.3.7.3.3]
9
Carrie Emma Northup
[1.7.6.4.12.1.3.7.4]
b. Jul 1883 d. 8 Oct 1966
Frank Waldo Curtis
b. 28 Jun 1885 d. 8 Jul 1967
10
Alfred Milton Curtis
[1.7.6.4.12.1.3.7.4.1]
b. 13 Jul 1909 d. 3 Jul 1942
10
Raymond Elton Curtis
[1.7.6.4.12.1.3.7.4.2]
b. 6 Mar 1912 d. 20 Sep 1920
6
Mary Whipple
[1.7.6.4.12.2]
b. 1765
6
Phebe Whipple
[1.7.6.4.12.3]
b. 1766 d. 21 Jul 1821
5
Moses Whipple
[1.7.6.4.13]
b. 21 Jan 1729 d. 3 Sep 1807
Patience Mathewson
b. 13 May 1736 d. 18 Jul 1812
6
Patience Whipple
[1.7.6.4.13.1]
b. 18 Jan 1767
6
William Whipple
[1.7.6.4.13.2]
b. 18 Dec 1768 d. 5 Aug 1839
6
Joseph Whipple
[1.7.6.4.13.3]
b. 8 Jul 1771 d. 11 Mar 1848
Anne Mathewson
b. 1775 d. 25 Nov 1825
7
Amey Whipple
[1.7.6.4.13.3.1]
b. 27 Jun 1797
7
Mary Ann Whipple
[1.7.6.4.13.3.2]
b. 27 Sep 1799 d. 20 Nov 1840
7
Joseph Whipple
[1.7.6.4.13.3.3]
b. 15 May 1803
7
Welcome Whipple
[1.7.6.4.13.3.4]
b. 13 Jul 1806
7
Sukey Whipple
[1.7.6.4.13.3.5]
b. 20 Jun 1808
7
Rebeckah Mathewson Whipple
[1.7.6.4.13.3.6]
b. 16 Oct 1810
7
Stephen Verry Whipple
[1.7.6.4.13.3.7]
b. 15 Feb 1813 d. 28 Oct 1876
Adeline Jenckes
b. 1 Apr 1818 d. 24 Sep 1897
8
Albert Jenckes Whipple
[1.7.6.4.13.3.7.1]
b. 16 Oct 1838 d. 13 Apr 1925
+
Medora G Crosby
b. 21 Nov 1846 d. 3 Jan 1867
+
Emily A Fisk
b. 4 Aug 1830 d. 23 Jul 1897
8
Moses Edward Whipple
[1.7.6.4.13.3.7.2]
b. Abt 1841 d. 10 Dec 1842
8
Amanda Ferdinand Whipple
[1.7.6.4.13.3.7.3]
b. 20 Jun 1848 d. 1 Aug 1938
George W Jenckes
b. 1850
9
Alice Gertrude Jencks
[1.7.6.4.13.3.7.3.1]
b. 28 Dec 1872 d. 11 Nov 1920
9
Grace Augusta Jenckes
[1.7.6.4.13.3.7.3.2]
b. 12 Feb 1875 d. 24 Aug 1961
Charles Edward Miller
b. 9 Jun 1875 d. 24 Aug 1934
10
Charles Edward Miller
[1.7.6.4.13.3.7.3.2.1]
b. 19 May 1899
10
Doris Grace Miller
[1.7.6.4.13.3.7.3.2.2]
b. 3 Mar 1906 d. 6 Aug 1948
+
George Francis Cogswell
b. 19 Mar 1906 d. 16 Feb 1983
9
Jennie Whipple Jenckes
[1.7.6.4.13.3.7.3.3]
b. 1 Sep 1876 d. 1955
8
Delia Mason Whipple
[1.7.6.4.13.3.7.4]
b. 7 Jun 1851 d. Aft 10 Jan 1920
Charles Mowrone Huling
9
Nellie May Huling
[1.7.6.4.13.3.7.4.1]
b. 24 Feb 1880 d. 25 May 1954
+
Alfred James Cardall
b. 5 Jun 1861 d. 26 Sep 1931
9
Bertha Miller Huling
[1.7.6.4.13.3.7.4.2]
b. 17 Jun 1882
William Douglas Strachan
b. 18 Jan 1881 bur. 1958
10
Dorothy W Strachan
[1.7.6.4.13.3.7.4.2.1]
b. 1909
10
Barbara M Strachan
[1.7.6.4.13.3.7.4.2.2]
b. 1913
9
Jessie Marion Huling
[1.7.6.4.13.3.7.4.3]
b. 24 Apr 1886
+
George Reuben Ramsbottom
b. 1888
9
Harris M Huling
[1.7.6.4.13.3.7.4.4]
b. 1 Jul 1888 d. Jun 1969
9
Ida Monroe Huling
[1.7.6.4.13.3.7.4.5]
b. 28 Feb 1896
9
Amey M Huling
[1.7.6.4.13.3.7.4.6]
b. 7 Oct 1900
8
Lewis Follett Whipple
[1.7.6.4.13.3.7.5]
b. 19 Aug 1861
+
Mary Tillinghast Whitford
6
Thankful Whipple
[1.7.6.4.13.4]
b. 20 May 1773 d. 16 Jul 1866
Nathaniel Spaulding
b. 15 Jul 1751 d. 10 Jun 1838
7
Lydia Spaulding
[1.7.6.4.13.4.1]
b. 6 Apr 1799
7
Mary Spaulding
[1.7.6.4.13.4.2]
b. 16 Mar 1801 d. 29 Jul 1863
+
Martin Arnold
b. 11 Nov 1783 d. 28 Oct 1847
7
Nathaniel Spaulding, Jr
[1.7.6.4.13.4.3]
b. 18 Mar 1803
Sarah Jenckes Mason
b. Abt 1803
8
Sarah H Spaulding
[1.7.6.4.13.4.3.1]
7
Thankful Spaulding
[1.7.6.4.13.4.4]
b. 6 Jul 1805 d. 17 Jan 1870
+
Nichols N Tuells
b. 1812 d. 1 Jun 1845
7
Hannah Spaulding
[1.7.6.4.13.4.5]
b. 15 Apr 1808 d. 6 Jun 1901
7
William Whipple Spaulding
[1.7.6.4.13.4.6]
b. 1 May 1810
Miranda Arnold
b. Abt 1815 d. 17 Jun 1901
8
Charles Frederick Spaulding
[1.7.6.4.13.4.6.1]
b. Abt Aug 1838 d. 27 Jan 1923
Charlotte Anne Jenckes
b. Sep 1835 d. 2 Apr 1921
9
Lottie May Spaulding
[1.7.6.4.13.4.6.1.1]
b. Abt 1871 d. 22 Nov 1883
8
Joseph Eleazer Spaulding
[1.7.6.4.13.4.6.2]
b. Abt 1838 d. 3 Feb 1915
Harriet Melissa Arnold
b. Abt 1844 d. 8 Oct 1914
9
Frank Edward Spaulding
[1.7.6.4.13.4.6.2.1]
b. Abt 1870 d. 21 Aug 1938
+
Sarah Ann Shaw
b. Abt 1887
9
Etta Belle Spaulding
[1.7.6.4.13.4.6.2.2]
b. 16 Dec 1890 d. Aft Apr 1910
8
George Henry Spaulding
[1.7.6.4.13.4.6.3]
b. Abt 1841 d. 9 Feb 1938
+
Abbie Williams Thayer
b. 1850 d. 1925
8
John Adams Spaulding
[1.7.6.4.13.4.6.4]
b. Abt 1843 d. 5 Dec 1916
Sarra Hopkins
9
John Hopkins Spaulding
[1.7.6.4.13.4.6.4.1]
b. 6 Sep 1869
8
Nathaniel Arnold Spaulding
[1.7.6.4.13.4.6.5]
b. 22 Feb 1847 d. 1937
Cora Belle Aldrich
b. Apr 1858 d. 1918
9
Alice Follett Spaulding
[1.7.6.4.13.4.6.5.1]
b. Dec 1880 d. 1969
Henry Moore
b. 23 Nov 1884 d. 16 Jan 1944
10
Henry E Moore
[1.7.6.4.13.4.6.5.1.1]
10
Marion Moore
[1.7.6.4.13.4.6.5.1.2]
9
Nathaniel Warren Spaulding
[1.7.6.4.13.4.6.5.2]
b. 11 Apr 1884 d. Aft 1942
Agnes Martha Vinton
b. Abt 1887 d. Aft 1942
10
Elsie V Spaulding
[1.7.6.4.13.4.6.5.2.1]
10
Nathaniel R Spaulding
[1.7.6.4.13.4.6.5.2.2]
8
Joshua Edwards Spaulding
[1.7.6.4.13.4.6.6]
b. May 1849 d. 11 Apr 1939
Ruhamah Caroline Wilson
b. May 1849 d. 19 Mar 1919
9
Arbella Wilson Spaulding
[1.7.6.4.13.4.6.6.1]
b. 4 Jan 1876
9
Everett Garfield Spaulding
[1.7.6.4.13.4.6.6.2]
b. 24 Apr 1880 d. 24 Aug 1945
+
Mae Estelle Meservey
b. Abt 1888
9
George Ernest Spaulding
[1.7.6.4.13.4.6.6.3]
b. 25 Jun 1884 d. Aft Apr 1930
8
William Whipple Spaulding, Jr
[1.7.6.4.13.4.6.7]
b. Abt 1852 d. 29 Nov 1893
+
Martha Ann Jollie
b. 22 Dec 1851 d. 7 Aug 1906
7
Sarah Spaulding
[1.7.6.4.13.4.7]
b. 9 Jan 1812 d. Jun 1846
7
John Newell Spaulding
[1.7.6.4.13.4.8]
b. 5 May 1815 d. 11 Jun 1881
Sarah Coggshall Vose
b. 1823 d. 28 Apr 1887
8
Mary Frances Spaulding
[1.7.6.4.13.4.8.1]
b. 1850 d. 26 May 1933
5
Joseph Whipple
[1.7.6.4.14]
b. 18 Apr 1731 d. 27 Dec 1760
5
Amey Whipple
[1.7.6.4.15]
b. 31 May 1732 d. Abt 1733
5
Eleazer Whipple
[1.7.6.4.16]
b. 20 Jan 1733 d. 22 Mar 1781
Anna Brown
b. 21 Aug 1736 d. 1805
6
Eleazer Whipple, Jr
[1.7.6.4.16.1]
b. 8 Nov 1758 d. 29 Jul 1825
Betty Bate
b. Abt 1758
7
David Whipple
[1.7.6.4.16.1.1]
b. 9 Jun 1789 d. 7 Jul 1858
Hannah Read
b. Abt 1801
8
Pardon R Whipple
[1.7.6.4.16.1.1.1]
b. 5 Oct 1828 d. 9 Aug 1905
8
Eliza Minerva Whipple
[1.7.6.4.16.1.1.2]
b. 25 Dec 1831 d. 21 Jan 1926
Stephen Phineas Eddy
b. 29 Feb 1844 d. Apr 1927
9
Jeremiah Phineas Eddy
[1.7.6.4.16.1.1.2.1]
b. 31 Oct 1869 d. 6 Apr 1939
9
George Osborne Eddy
[1.7.6.4.16.1.1.2.2]
b. 18 Apr 1871
+
Lydia Frances Harrington
b. 19 Feb 1869 d. 18 Feb 1922
9
Maria Arilla Eddy
[1.7.6.4.16.1.1.2.3]
b. 18 Jun 1872
9
Charles Francis Eddy
[1.7.6.4.16.1.1.2.4]
b. 26 May 1874 d. 25 Feb 1875
9
Charles Francis Eddy
[1.7.6.4.16.1.1.2.5]
b. 18 May 1876 d. 12 May 1907
+
Jeremiah Whipple
b. 1840 d. 18 Jul 1866
8
Hyson Paine Whipple
[1.7.6.4.16.1.1.3]
b. 1834 d. 5 Jun 1888
+
Ellen Robertson Howie
b. 30 Aug 1870
7
Sally Whipple
[1.7.6.4.16.1.2]
b. 13 Apr 1792 d. 11 Mar 1879
Emerson Tower
b. 31 Jan 1789 d. 23 Oct 1862
8
Emerson Tower
[1.7.6.4.16.1.2.1]
b. 29 Jun 1818 d. 23 Apr 1870
Elizabeth Adeline Hidden
b. 23 May 1815
9
James Henry Tower
[1.7.6.4.16.1.2.1.1]
b. 21 May 1847 d. 13 Aug 1921
Julia Wilkinson Sayles
b. 17 Feb 1848 d. 8 Sep 1910
10
Clifford Sayles Tower
[1.7.6.4.16.1.2.1.1.1]
b. 13 Nov 1867
10
Lewis Philip Tower
[1.7.6.4.16.1.2.1.1.2]
b. 6 Mar 1869
10
Mona Elizabeth Tower
[1.7.6.4.16.1.2.1.1.3]
b. 9 Mar 1871
8
Delila Tower
[1.7.6.4.16.1.2.2]
b. 14 Nov 1828
Francis Prue
b. 17 Dec 1828
9
Cornelius W Prue
[1.7.6.4.16.1.2.2.1]
b. 4 Jul 1851
9
Ella G Prue
[1.7.6.4.16.1.2.2.2]
b. 25 Mar 1854
9
Ruth Ann Prue
[1.7.6.4.16.1.2.2.3]
b. 5 Sep 1856
9
Elmira Whipple Prue
[1.7.6.4.16.1.2.2.4]
b. 11 Mar 1850
Alvan Henry Langley
b. Abt 1848
10
Alvin Langley
[1.7.6.4.16.1.2.2.4.1]
b. 12 Nov 1872
10
Elmira Ella Langley
[1.7.6.4.16.1.2.2.4.2]
b. 13 Sep 1883
8
Chloe Tower
[1.7.6.4.16.1.2.3]
b. 14 Nov 1830
William Knight
b. 1830 d. Bef 19 Oct 1859
9
Winfield Scott Knight
[1.7.6.4.16.1.2.3.1]
b. 19 Aug 1850
Ida M Pierce
b. 27 Jan 1858
10
Percy Winfield Knight
[1.7.6.4.16.1.2.3.1.1]
b. 21 Feb 1879 d. 24 Mar 1957
Lena I Baker
b. 8 Jun 1878 d. 26 May 1971
11
Winfield Baker Knight
[1.7.6.4.16.1.2.3.1.1.1]
b. 10 Jun 1918 d. 8 Sep 2001
10
Mabel May Knight
[1.7.6.4.16.1.2.3.1.2]
b. 22 Apr 1880
10
Mary E. Knight
[1.7.6.4.16.1.2.3.1.3]
b. 8 Jun 1884 d. 22 Aug 1884
+
E M Capron
b. Abt 1825
8
Ruth Ann Tower
[1.7.6.4.16.1.2.4]
b. 15 May 1832 d. 21 Jan 1835
8
Zillah Tower
[1.7.6.4.16.1.2.5]
b. 27 Sep 1834 d. 15 Oct 1900
Hiram W Baylies
b. 12 Oct 1828 d. 17 Jan 1901
9
Emerson Horatio Baylies
[1.7.6.4.16.1.2.5.1]
b. 5 May 1861 d. 10 Jul 1928
9
Nicholas L Baylies
[1.7.6.4.16.1.2.5.2]
b. 12 Aug 1865 d. 27 May 1882
9
Harriet Eliza Baylies
[1.7.6.4.16.1.2.5.3]
b. 13 May 1869 d. 30 Sep 1911
John Edward Hayes
b. 12 May 1865
10
Lewis Francis Hayes
[1.7.6.4.16.1.2.5.3.1]
b. 25 Dec 1897
9
Adeline Frances Baylies
[1.7.6.4.16.1.2.5.4]
b. 16 Sep 1871 d. Aug 1874
9
Helen Patience Baylies
[1.7.6.4.16.1.2.5.5]
b. 3 Nov 1875
9
Mary Elizabeth Baylies
[1.7.6.4.16.1.2.5.6]
b. 21 Jan 1878
7
Isaac Whipple
[1.7.6.4.16.1.3]
b. 21 Oct 1794 d. 1 Jul 1796
7
Almira Whipple
[1.7.6.4.16.1.4]
b. 1 Apr 1797
7
Cornelius Whipple
[1.7.6.4.16.1.5]
b. 6 Oct 1800
6
Joseph Whipple
[1.7.6.4.16.2]
b. 6 Dec 1760 d. 3 Mar 1826
Mercy Mary Follett
b. 14 Dec 1758
7
Lidia Whipple
[1.7.6.4.16.2.1]
b. 4 Apr 1788
Adam Polsey
b. 12 Jul 1784
8
Mary Polsey
[1.7.6.4.16.2.1.1]
b. Abt 1806
Stephen Joslin
b. 6 Aug 1803 d. Bef 1865
9
Adam Joslin
[1.7.6.4.16.2.1.1.1]
b. 1829 d. 1 Jan 1875
+
Maranda Crossman
b. Abt 1832 d. Bef 1860
Mary Elizabeth Billings
b. 26 May 1837
10
Son Joslin
[1.7.6.4.16.2.1.1.1.1]
b. Abt 1860
10
Son Joslin
[1.7.6.4.16.2.1.1.1.2]
b. Abt 1876
9
Ann Elizabeth Joslin
[1.7.6.4.16.2.1.1.2]
b. Abt 1834
Richard A Briggs
b. 1830 d. Bef 1940
10
George A Briggs
[1.7.6.4.16.2.1.1.2.1]
b. 1852 d. Bef 1962
10
Alfonso Briggs
[1.7.6.4.16.2.1.1.2.2]
b. 1855 d. Bef 1965
10
Ann Briggs
[1.7.6.4.16.2.1.1.2.3]
b. 1858 d. 2 Sep 1880
+
William Wallace Prance
b. Feb 1855 d. 8 Aug 1924
10
Mary L Briggs
[1.7.6.4.16.2.1.1.2.4]
b. 1860 d. Bef 1970
10
Georgiana Briggs
[1.7.6.4.16.2.1.1.2.5]
b. 1863 d. Bef 1974
10
Cora Almira Briggs
[1.7.6.4.16.2.1.1.2.6]
b. 11 Mar 1866
10
Lila A Briggs
[1.7.6.4.16.2.1.1.2.7]
b. 1871
10
Richard Albertus Briggs
[1.7.6.4.16.2.1.1.2.8]
b. 4 Aug 1878
9
Horatio Joslin
[1.7.6.4.16.2.1.1.3]
b. 1835
8
Jospeh Whipple Polsey
[1.7.6.4.16.2.1.2]
b. 1807 d. 30 Oct 1826
8
Alanson Polsey
[1.7.6.4.16.2.1.3]
b. 23 Jul 1819 d. 16 Aug 1891
Mary A C Smith
b. 18 May 1821 d. 8 Jan 1886
9
Estelle G Polsey
[1.7.6.4.16.2.1.3.1]
b. 1844
+
Royal Otis Butman
9
Alice Jane Polsey
[1.7.6.4.16.2.1.3.2]
b. 1845
+
Henry Davis Wyatt
9
Charles Edward Polsey
[1.7.6.4.16.2.1.3.3]
b. 9 May 1846 d. 30 Oct 1880
Hannah Bishop Boss
b. 29 Oct 1849 d. 13 Dec 1930
10
Eva Belle Polsey
[1.7.6.4.16.2.1.3.3.1]
b. 11 Jan 1874 d. 1 Jun 1940
Charles Lincoln Moody
b. 25 May 1870 d. 21 Jun 1943
11
Clifford Edward Moody
[1.7.6.4.16.2.1.3.3.1.1]
b. 16 Jul 1893 d. Apr 1979
11
Olive Bishop Moody
[1.7.6.4.16.2.1.3.3.1.2]
b. 21 Dec 1894
11
Alma Lincoln Moody
[1.7.6.4.16.2.1.3.3.1.3]
b. 17 May 1896
11
Norman P Moody
[1.7.6.4.16.2.1.3.3.1.4]
b. 28 Jul 1901 d. Mar 1976
11
Walter Leland Moody
[1.7.6.4.16.2.1.3.3.1.5]
b. 29 Apr 1908 d. 12 Aug 1983
+
Florence Verna Greene
b. 15 Jan 1907 d. 15 Oct 1973
11
Stewart H Moody
[1.7.6.4.16.2.1.3.3.1.6]
b. 3 May 1913 d. May 1965
10
Walter Leland Polsey
[1.7.6.4.16.2.1.3.3.2]
b. 29 Jun 1876
+
Ethel Isabel Steere
b. 22 Nov 1882
9
Maria Adelaide Polsey
[1.7.6.4.16.2.1.3.4]
b. 1848
+
Maxey A Steere
9
Abby E Polsey
[1.7.6.4.16.2.1.3.5]
b. 1851
9
Henry S Polsey
[1.7.6.4.16.2.1.3.6]
b. 1853
9
Edgar Clark Polsey
[1.7.6.4.16.2.1.3.7]
b. 1855 d. 1889
Fannie Amelia Palmer
b. 1855
10
William Henry Clarence Polsey
[1.7.6.4.16.2.1.3.7.1]
b. 6 Apr 1882 d. 30 Jun 1885
+
Susan Helen Cameron
b. Dec 1864
9
Annie M Polsey
[1.7.6.4.16.2.1.3.8]
b. 1863 d. 29 May 1894
Willis H Tucker
b. Feb 1854
10
Alice Estelle Tucker
[1.7.6.4.16.2.1.3.8.1]
b. 26 Jul 1891
8
Cynthia Ann Polsey
[1.7.6.4.16.2.1.4]
b. 19 Mar 1826
Joshua S Clarke
b. 1825
9
Ellery Benton Clark
[1.7.6.4.16.2.1.4.1]
b. Sep 1857
+
Addie Mary Warren
b. 23 Jul 1853
7
John Whipple
[1.7.6.4.16.2.2]
b. 13 Jul 1790 d. 1843
Elizabeth Baker
b. Abt 1794 d. 1865
8
Amy Whipple
[1.7.6.4.16.2.2.1]
b. 1819
8
Benjamin Whipple
[1.7.6.4.16.2.2.2]
b. 18 Jun 1821
+
Helen Valentine Raymond
b. 5 Jun 1831 d. 7 Jul 1888
8
Mary Jane Whipple
[1.7.6.4.16.2.2.3]
b. Abt 1823
8
Joseph Arnold Whipple
[1.7.6.4.16.2.2.4]
b. 27 Jan 1826 d. 18 Jan 1910
+
Susan Fenner Snow
b. Jun 1848 bur. 10 Dec 1925
8
Charles William Whipple
[1.7.6.4.16.2.2.5]
b. Abt 1828
8
Annie Elizabeth Whipple
[1.7.6.4.16.2.2.6]
b. 1830
8
Alpha Anna Whipple
[1.7.6.4.16.2.2.7]
b. 1832
8
Irene Victoria Whipple
[1.7.6.4.16.2.2.8]
b. 1834
Joseph Henry Hoyt
b. 1837 d. 19 Mar 1920
9
Walter H Hoyt
[1.7.6.4.16.2.2.8.1]
b. 26 Nov 1858
7
Benjamin Whipple
[1.7.6.4.16.2.3]
b. 6 Sep 1796 d. 7 Apr 1798
7
Levi Whipple
[1.7.6.4.16.2.4]
b. 7 Sep 1798
7
Joanna Whipple
[1.7.6.4.16.2.5]
b. 20 Mar 1809 d. 1868
Jesse Mason
b. 22 Dec 1798
8
Jerome Jesse Mason
[1.7.6.4.16.2.5.1]
b. 21 Aug 1837
6
Susannah Whipple
[1.7.6.4.16.3]
b. 11 Jul 1762 d. 1 Feb 1832
Joshua Jenckes
b. 15 Jan 1754 d. Jun 1807
7
Salinda Jenckes
[1.7.6.4.16.3.1]
b. 21 Feb 1799 d. 2 Feb 1856
+
William Howard
b. Abt 1797
7
Anphillas Jenckes
[1.7.6.4.16.3.2]
b. 25 Sep 1800
7
Parley Jenckes
[1.7.6.4.16.3.3]
b. 31 Jan 1802 d. 28 Mar 1866
+
Newel Phetteplace
b. Abt 1804
7
Hannah Jenckes
[1.7.6.4.16.3.4]
b. 1 Jul 1803 d. 1852
7
Lemuel Jenckes
[1.7.6.4.16.3.5]
b. Abt 1805 d. 10 Jul 1845
6
Anne Whipple
[1.7.6.4.16.4]
b. 12 Feb 1766
6
Betsey Whipple
[1.7.6.4.16.5]
b. 9 Jan 1768 d. Aft 1811
Christopher Dexter
b. 1770 d. Aft 1811
7
Anthony Dexter
[1.7.6.4.16.5.1]
b. 1791
Mary Ann Dexter
b. 1791 d. 13 Dec 1851
8
Elsie Dexter
[1.7.6.4.16.5.1.1]
b. 1817
8
Abby Dexter
[1.7.6.4.16.5.1.2]
b. 1819
8
Albert Dexter
[1.7.6.4.16.5.1.3]
b. 1821
Mary Cobb
b. 1822
9
Mary Dexter
[1.7.6.4.16.5.1.3.1]
b. 1845
8
Louisa Dexter
[1.7.6.4.16.5.1.4]
b. 1825
8
Adaline Dexter
[1.7.6.4.16.5.1.5]
b. 1827
8
Mary Dexter
[1.7.6.4.16.5.1.6]
b. 1828
7
Susan Dexter
[1.7.6.4.16.5.2]
b. 1793
7
Amy Dexter
[1.7.6.4.16.5.3]
b. 1796
7
Mary Dexter
[1.7.6.4.16.5.4]
b. Abt 1799 d. 30 May 1937
Lodowick Walcott
b. 27 Sep 1795 d. 22 Feb 1841
8
Charles Stuart Walcott
[1.7.6.4.16.5.4.1]
b. 13 Jul 1826 d. 6 Apr 1871
Mary Catherine Leary
b. 5 May 1850 d. 28 Apr 1913
9
Mary Dexter Walcott
[1.7.6.4.16.5.4.1.1]
b. 22 May 1868 d. 1932
9
Gregory Dexter Walcott
[1.7.6.4.16.5.4.1.2]
b. 29 Aug 1869
8
William Henry Walcott
[1.7.6.4.16.5.4.2]
b. 9 Jul 1828 d. 30 Aug 1901
Georgie Josephine Weaver
b. 21 Jan 1852 d. 28 Mar 1926
9
Clinton D S Walcott
[1.7.6.4.16.5.4.2.1]
b. 19 Jun 1873
9
Maude V Peyton Walcott
[1.7.6.4.16.5.4.2.2]
b. 28 Dec 1874
9
Blanche D R Walcott
[1.7.6.4.16.5.4.2.3]
b. 27 May 1876
9
William H L Walcott
[1.7.6.4.16.5.4.2.4]
b. 11 Nov 1879
9
George D Walcott
[1.7.6.4.16.5.4.2.5]
b. Jul 1886
9
Amy Dexter Walcott
[1.7.6.4.16.5.4.2.6]
b. Sep 1888 d. Sep 1888
9
Georgia Dexter Walcott
[1.7.6.4.16.5.4.2.7]
b. Sep 1888 d. Sep 1888
7
Betsey Dexter
[1.7.6.4.16.5.5]
b. 18 Mar 1803
Orin Smith
8
Joseph Orville Smith
[1.7.6.4.16.5.5.1]
b. 1843 d. 1920
7
Maria Dexter
[1.7.6.4.16.5.6]
b. 1805
7
Christopher C Dexter
[1.7.6.4.16.5.7]
b. 1807
7
Caroline Dexter
[1.7.6.4.16.5.8]
b. Abt 1812 d. 6 Jun 1866
Christopher Whipple Kelly
b. 1811 d. 30 Mar 1858
8
Mary Kelly
[1.7.6.4.16.5.8.1]
b. 27 Feb 1832 d. 10 Sep 1906
Edward Cooke
b. 28 May 1836 d. 14 Oct 1897
9
Abigail Whipple Cooke
[1.7.6.4.16.5.8.1.1]
b. 1862 d. 6 Jul 1919
8
George D Kelly
[1.7.6.4.16.5.8.2]
b. 1835 d. 19 Feb 1891
Mary Ann Mathewson
b. Abt 1838 d. 6 Aug 1889
9
Abby Burton Kelley
[1.7.6.4.16.5.8.2.1]
b. 13 Mar 1864 d. 21 May 1875
9
George D Kelly, Jr
[1.7.6.4.16.5.8.2.2]
b. 1866 d. 23 Sep 1875
8
Anna Kelly
[1.7.6.4.16.5.8.3]
b. 1835 d. 1 Jan 1905
William Henry Congdon
b. 1828 d. 27 Jul 1878
9
William Rhodes Congdon
[1.7.6.4.16.5.8.3.1]
b. 22 May 1872 d. 1920
Almira Avis Hoxie
b. 1878 d. 1971
10
Mildred H Congdon
[1.7.6.4.16.5.8.3.1.1]
b. 1902 d. 1925
9
Helena Florence Congdon
[1.7.6.4.16.5.8.3.2]
b. 7 May 1876
8
Caroline Dexter Kelly
[1.7.6.4.16.5.8.4]
b. 1848 d. 16 Mar 1935
6
Jesse Whipple
[1.7.6.4.16.6]
b. 7 Feb 1771 d. 3 Jul 1840
Percy Anna Streeter
b. 21 Aug 1776 d. 1856
7
Jabez Whipple
[1.7.6.4.16.6.1]
b. 18 Aug 1803 d. 12 Dec 1873
Susan Benton
b. 16 Mar 1808 d. 5 Nov 1883
8
Levi B Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.1]
b. 13 Dec 1825 d. 30 Mar 1905
Elizabeth B Seely
b. Abt 1829 d. 1855
9
William Calvin Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.1.1]
b. 10 Sep 1852 d. 3 Dec 1859
9
Rial Raneford Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.1.2]
b. 31 Aug 1853 d. 9 Jan 1898
Alice Dunn
b. 4 Jan 1865 d. 24 Jun 1933
10
Edgar Clinton Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.1.2.1]
b. 3 Dec 1881 d. 10 Jun 1950
Maggie Jane Purvis
b. 2 Sep 1877 d. 4 Sep 1972
11
Pauline Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.1.2.1.1]
b. 12 Aug 1907 d. 25 Mar 2009
Harold Elmer Taylor
b. 4 Sep 1910 d. 28 Dec 1988
12
Alice Marie Taylor
[1.7.6.4.16.6.1.1.2.1.1.1]
b. 10 Jul 1932 d. 31 Mar 2008
12
Shirley Ann Taylor
[1.7.6.4.16.6.1.1.2.1.1.2]
b. 19 Apr 1934 d. 18 Feb 2001
12
Phyllis Joan Taylor
[1.7.6.4.16.6.1.1.2.1.1.3]
b. 25 Sep 1936 d. 31 Jul 1989
Jane Patterson
b. 6 Oct 1840 d. 30 Apr 1914
9
Walter S Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.1.3]
b. 6 Jun 1861 d. 7 Aug 1923
Gertrude Hodson
b. Mar 1876 d. 1953
10
James Earl Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.1.3.1]
b. 4 May 1896 d. 31 Dec 1969
+
Nellie E Evans
b. Abt 1900
10
Nellie Mae Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.1.3.2]
b. Jan 1898 d. 1942
+
James E Parker
b. 1897
10
Mary Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.1.3.3]
b. 16 Jan 1900 d. 15 Nov 1990
9
Edgar Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.1.4]
b. 1864 d. 1943
+
Jennie Logan
b. Abt 1868 d. 29 May 1908
+
Rosa Simmonds
b. 1870 d. 15 Nov 1944
9
Charles A Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.1.5]
b. 1873 d. 8 Aug 1964
Mary E Purvis
b. 29 Feb 1876 d. 6 Apr 1964
10
Wayne O Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.1.5.1]
b. 1897 d. 30 Oct 1978
+
Marie Mae Robbins
b. 1 Feb 1898 d. 17 Jul 1974
10
Marle Benton Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.1.5.2]
b. 1901 d. 14 Jul 1990
+
Olive Woodsides
b. 20 Nov 1900 d. 18 Feb 1978
10
Gladys Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.1.5.3]
b. 1904
10
Zelma R Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.1.5.4]
b. 1 Jan 1905 d. Jan 1984
James Hendrix
b. 1900 d. 1986
11
Gerald Thomas Hendrix
[1.7.6.4.16.6.1.1.5.4.1]
b. 16 Jun 1921 d. 16 Dec 2007
+
Fay Leona Price
b. 31 May 1925 d. 27 Apr 1997
11
Robert Hendrix
[1.7.6.4.16.6.1.1.5.4.2]
b. 20 May 1929 d. 19 Nov 1981
10
Bernice Florine Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.1.5.5]
b. 1913 d. 31 Oct 1963
8
Oscar F Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.2]
b. 18 May 1827 d. 19 Sep 1905
Mary Watkins
b. 1829 d. Abt 1865
9
Henry Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.2.1]
b. Abt 1854
9
Jonathan Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.2.2]
b. Abt 1856
9
Rinaldo Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.2.3]
b. 21 Oct 1859 d. 20 Jun 1925
9
Mary Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.2.4]
b. Abt 1862
9
Elsworth Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.2.5]
b. Aug 1863 d. 8 Nov 1892
9
Grant Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.2.6]
b. Abt 1864
9
Laura Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.2.7]
b. Abt 1866
9
Ira Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.2.8]
b. Abt 1868
8
Erwin A Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.3]
b. Mar 1829 d. 1912
Catherine Larimore
b. 1833 d. 1911
9
Arnold Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.3.1]
b. Abt 1853
Prudence
10
Mable Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.3.1.1]
b. Abt 1884
9
Mary Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.3.2]
b. Abt 1855
+
Katie Calheynst
b. Abt 1833
8
Alfred J Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.4]
b. 26 Feb 1831 d. 27 Jan 1909
Mary Ann Redmon
b. 1835 d. Abt 1866
9
Ed Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.4.1]
b. 1857
9
Laura Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.4.2]
b. 1859
9
Milo Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.4.3]
b. 1861
Elizabeth C Doak
b. 3 Dec 1832 d. 2 Mar 1919
9
Ettie Jane Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.4.4]
b. 1869
9
Laura Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.4.5]
b. 1871
9
Milo Doak Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.4.6]
b. 30 Jan 1873
Mary May Buchanan
b. 11 Jun 1874 d. 1 Jun 1947
10
Wayne Buchanan Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.4.6.1]
b. 23 Jul 1901 bur. Sep 1975
10
Robert Donal Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.4.6.2]
b. 14 Feb 1903
8
John Calvin Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.5]
b. 1833 d. 7 Aug 1893
Priscilla Gray
b. 27 Apr 1834 d. 3 Dec 1880
9
Sarah Angeline Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.5.1]
b. 6 Jun 1856 d. 17 May 1939
+
William Arthur Dorr
b. 13 Dec 1855 d. 22 Jul 1939
9
Clara Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.5.2]
b. Abt 1858
9
Susan Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.5.3]
b. Abt 1861
9
Jennie Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.5.4]
b. Abt 1863
9
Cordellia Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.5.5]
b. Abt 1867
9
Bernice Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.5.6]
b. 29 Aug 1868 d. 1963
9
Kotorah Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.5.7]
b. Abt 1869
9
Oscar F Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.5.8]
b. 1870
9
Vernitia Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.5.9]
b. Abt 1871
9
William Marion Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.5.10]
b. 24 Jun 1873 d. 10 May 1938
Bertha Bell Warder
b. 28 Feb 1875 d. 11 Mar 1959
10
Hazel M Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.5.10.1]
b. 25 Sep 1897 d. 11 Aug 1991
10
John C W Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.5.10.2]
b. 4 Mar 1900 d. 28 Jan 1965
10
William Alden Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.5.10.3]
b. 10 Feb 1905 d. 4 Aug 1960
+
Nadine Faye Goodman
b. 9 Feb 1916 d. 26 Feb 1966
8
William Theodore Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6]
b. 10 Apr 1835 d. 1 Aug 1908
Emily Theresa O'Donnell
b. 16 Dec 1844 d. 2 Dec 1875
9
William Theodore "Willie" Whipple, Jr
[1.7.6.4.16.6.1.6.1]
b. 1863 d. 1899
Jesse Beckwith
b. 1870 d. Abt 1918
10
Henry Theodore Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.1.1]
b. 18 Feb 1890 d. 12 Mar 1963
+
Mary Magdalene Redford
b. 18 Apr 1884 d. 26 Oct 1918
Daisy Terrell
b. Abt 1894
11
Kenneth Glen Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.1.1.1]
b. Abt 1920 d. 14 Nov 1942
11
Doyle H Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.1.1.2]
b. 9 Sep 1921 d. 7 Apr 2008
Roma Florence Walker
12
Doyle H Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.1.1.2.1]
[
=>
]
11
Anita J Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.1.1.3]
+
Merlin Henry
10
Harvey Clyde Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.1.2]
b. 4 Feb 1892 d. 11 Jun 1939
Grace McGee
b. Abt 1897
11
Helen Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.1.2.1]
Robert Towles
12
Randall Towles
[1.7.6.4.16.6.1.6.1.2.1.1]
12
Donald Towles
[1.7.6.4.16.6.1.6.1.2.1.2]
12
Carolyn Towles
[1.7.6.4.16.6.1.6.1.2.1.3]
11
Mary Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.1.2.2]
Robert Sitton
12
Marylynne Sitton
[1.7.6.4.16.6.1.6.1.2.2.1]
12
Robert Sitton
[1.7.6.4.16.6.1.6.1.2.2.2]
12
Michael Sitton
[1.7.6.4.16.6.1.6.1.2.2.3]
10
Edith Mertie "Ada" Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.1.3]
b. 30 Nov 1895 d. 25 Mar 1981
Leon Claudis Neel
b. Abt 1891
11
Woodrow Neel
[1.7.6.4.16.6.1.6.1.3.1]
11
Margaret Neel
[1.7.6.4.16.6.1.6.1.3.2]
11
Harvey Neel
[1.7.6.4.16.6.1.6.1.3.3]
11
Marvin Neel
[1.7.6.4.16.6.1.6.1.3.4]
11
Evelyn Neel
[1.7.6.4.16.6.1.6.1.3.5]
11
William Neel
[1.7.6.4.16.6.1.6.1.3.6]
11
Jack Neel
[1.7.6.4.16.6.1.6.1.3.7]
11
Harold Neel
[1.7.6.4.16.6.1.6.1.3.8]
11
Helen Neel
[1.7.6.4.16.6.1.6.1.3.9]
11
Thomas Neel
[1.7.6.4.16.6.1.6.1.3.10]
11
Marthellen Neel
[1.7.6.4.16.6.1.6.1.3.11]
9
Alva Leonidas Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.2]
b. 31 Jul 1866 d. 2 Sep 1951
Mattie Bell Walker
b. 8 May 1870 d. 3 Jul 1889
10
Alva Leonidas Whipple, Junior
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.1]
b. 10 Jun 1889 d. 10 Jun 1889
Louise Justine Elstner
b. 26 Nov 1873 d. 20 Feb 1964
10
Ethel Louise Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.2]
b. 1 Apr 1895 d. 24 Mar 1981
Arthur Austin Jost
b. 2 Feb 1891 d. 11 Aug 1956
11
Edwin Oliver Jost
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.2.1]
b. 17 Mar 1915 d. 22 Oct 1939
Lorriene Keele
12
Patricia Jost
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.2.1.1]
11
Leonard Howard Jost
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.2.2]
b. 28 Feb 1918 d. 27 Oct 1997
Willa Nell Dodson
b. 30 Oct 1922 d. 21 May 2013
12
Gary Jost
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.2.2.1]
12
Judith Jost
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.2.2.2]
[
=>
]
12
Janet Jost
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.2.2.3]
[
=>
]
12
Linda Jost
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.2.2.4]
[
=>
]
11
Mildred Louise Jost
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.2.3]
b. 3 Sep 1919 d. 12 Aug 1989
Brownie Peters
12
John Peters
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.2.3.1]
[
=>
]
12
Susan Peters
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.2.3.2]
[
=>
]
12
Brownie Peters
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.2.3.3]
[
=>
]
12
Stephen Peters
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.2.3.4]
[
=>
]
Brownie Oats Peters
b. 26 Jan 1915 d. 26 Aug 1994
12
John Noel Peters
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.2.3.5]
b. 12 Mar 1942 d. 2 May 2014
10
Harry Lee Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.3]
b. 11 Mar 1897 d. 19 Dec 1985
Mary Louise Lopez
b. 28 Sep 1900 d. 13 Apr 1985
11
Harry Lee Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.3.1]
Leona Machala
12
Harry Lee "Chuck" Whipple, III
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.3.1.1]
[
=>
]
12
James Louis Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.3.1.2]
12
Mary Ann Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.3.1.3]
11
James Olive "Jimmy" Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.3.2]
b. 7 Aug 1922 d. 1 Apr 1989
Jane Smith
12
James Craig Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.3.2.1]
[
=>
]
12
Kenneth L Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.3.2.2]
[
=>
]
12
Larry A Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.3.2.3]
[
=>
]
10
Edwin Clyde Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.4]
b. 14 Aug 1898 d. 17 May 1979
Edna Smith
b. Abt 1902 d. Bef 1976
11
Edwin Whipple, Jr
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.4.1]
b. 30 May 1932 d. Dec 1976
Patricia
12
John Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.4.1.1]
12
Carol Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.4.1.2]
12
Sharon Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.4.1.3]
11
Robert Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.4.2]
Jean Bright
12
Larry Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.4.2.1]
12
Sheri Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.4.2.2]
12
Robert Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.4.2.3]
10
Floyd Cleo Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.5]
b. 19 Mar 1900 d. 29 Dec 1975
Grace Thomas
b. 9 Mar 1906 d. 29 Aug 1984
11
Floyd Vance Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.5.1]
b. 18 Aug 1928 d. 6 Aug 1998
Ursella Lou Stowell
b. 12 Apr 1934 d. 20 Aug 1969
12
Garry Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.5.1.1]
12
Lauri Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.5.1.2]
12
Cynthia Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.5.1.3]
12
Curtis Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.5.1.4]
Peggy Lue Nichols
12
Coty Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.5.1.5]
11
Mary Lou Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.5.2]
b. 28 Apr 1933 d. 27 Apr 2005
Orville Emmett Hawk
b. 9 Jul 1936 d. 14 Aug 1986
12
Mark Hawk
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.5.2.1]
12
Scott Cameron Hawk
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.5.2.2]
b. 5 Dec 1956 d. 25 Mar 2006
12
Kevin Hawk
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.5.2.3]
12
Jonathan Hawk
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.5.2.4]
12
Jeffrey Jerome Hawk
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.5.2.5]
b. 1 Sep 1966 d. 19 Jan 2011
11
Thomas Alva Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.5.3]
b. 15 Feb 1937 d. 31 Oct 2013
Betty Jo White
b. 7 Mar 1941 d. 21 May 1993
12
Roxanne Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.5.3.1]
b. 26 Jul 1958 d. 24 Jul 1966
12
Thomas Alva Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.5.3.2]
[
=>
]
12
Rory Lee Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.5.3.3]
[
=>
]
12
Michael Burke Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.5.3.4]
[
=>
]
+
Cheryl Lawson
10
Florence Effie Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.6]
b. 13 Sep 1901 d. 25 May 1995
Edgar W "Ed" Schroeder
b. 29 Oct 1900 d. May 1986
11
Lavonne Schroeder
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.6.1]
Jack Cayot
12
Leslie Cayot
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.6.1.1]
12
Jackson Cayot
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.6.1.2]
11
Living
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.6.2]
Billy Story
12
Mark Story
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.6.2.1]
12
Linda Story
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.6.2.2]
12
Alan Story
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.6.2.3]
10
Olive James "OJ" Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.7]
b. 20 Jul 1905 d. 27 May 1983
Mary Louise Ilderton
b. 9 Oct 1909 d. 10 Mar 1994
11
Jeanne Alva Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.7.1]
Living
12
Larry Mack Shaw
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.7.1.1]
[
=>
]
11
Jerrie Lee Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.7.2]
b. 14 Jan 1933 d. 28 Mar 2002
William Thomas Wilson
b. 30 Jan 1932 d. 30 Dec 2004
12
James Wilson
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.7.2.1]
[
=>
]
12
John Wilson
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.7.2.2]
[
=>
]
12
Robert Wilson
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.7.2.3]
12
Don Wilson
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.7.2.4]
[
=>
]
11
Olive James "Buddy" Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.7.3]
Nancy Dunford
b. 6 Sep 1938 d. 20 Sep 2004
12
Terri Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.7.3.1]
[
=>
]
12
Mark Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.7.3.2]
[
=>
]
12
Joseph Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.2.7.3.3]
[
=>
]
9
Augusta Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.3]
b. 24 Jul 1868 d. 10 Apr 1884
9
Son Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.4]
b. 24 Jan 1871 d. 24 Jan 1871
9
Ollie Mae Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.5]
b. 16 Apr 1872 d. 1 Mar 1942
John Wesley Underwood
b. Abt 1868 d. Bef 1939
10
Edna Underwood
[1.7.6.4.16.6.1.6.5.1]
b. 1891
+
Davis
b. Abt 1887
10
Lenie Underwood
[1.7.6.4.16.6.1.6.5.2]
b. 1897
+
Lee
b. Abt 1893
10
Robert Underwood
[1.7.6.4.16.6.1.6.5.3]
b. 1904
10
Claude W "Tony" Underwood
[1.7.6.4.16.6.1.6.5.4]
b. 1909 d. Nov 1976
+
Ruth Fanny
10
Juanita Underwood
[1.7.6.4.16.6.1.6.5.5]
+
Ritchey
9
Daughter Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.6]
b. 12 Feb 1874 d. 12 Feb 1874
9
Charles Theodore Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.7]
b. 12 Feb 1874 d. 1 May 1944
Alice Donaldson
b. Abt 1877
10
Roy Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.1]
b. 13 Jan 1899 d. 16 Oct 1972
Mittie Lilledrith
b. Abt 1899
11
Harold Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.1.1]
b. 1937 d. 1973
+
Viola
b. Abt 1900
+
Marie Batson
b. Abt 1878
Marcella Mary Raidt
b. 29 Sep 1891 d. 10 Feb 1920
10
John William Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.2]
b. 23 May 1908 d. 18 Nov 1978
+
Ruby Williams
b. Abt 1908 d. 1931
Ola Lee Cathey
b. 29 Jun 1902 d. 10 Dec 1950
11
John Nicholas Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.2.1]
Lucille Carstensen
12
Daniel John Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.2.1.1]
12
Catherine Sue Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.2.1.2]
Ginger
12
Sarah Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.2.1.3]
+
Hallie Sue Capps
10
Ivy Catharine Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.3]
b. 1910 d. 1931
10
Mildred Elizabeth Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.4]
b. 29 Jan 1912 d. 9 May 2001
Carl Henry Wegner
11
David Wegner
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.4.1]
Eileen Hilbern
12
David Wegner
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.4.1.1]
12
Sherry Wegner
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.4.1.2]
12
Jennifer Wegner
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.4.1.3]
12
Sally Wegner
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.4.1.4]
11
Lois Esther Wegner
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.4.2]
Steve Koppelmann
12
Kim Koppelmann
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.4.2.1]
12
Russell Koppelmann
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.4.2.2]
11
Paul Frederick "Fritz" Wegner
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.4.3]
Jimmie Myers
12
Gary Wegner
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.4.3.1]
b. 22 Aug 1962 d. 31 Oct 1994 [
=>
]
12
Paula Wegner
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.4.3.2]
[
=>
]
12
Lynet Wegner
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.4.3.3]
[
=>
]
11
Ruth E Wegner
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.4.4]
Roy Starks
12
Samuel Starks
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.4.4.1]
[
=>
]
12
John Starks
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.4.4.2]
b. 30 Jun 1964 d. 2004
+
Earl Boyer
11
Mary Jane Wegner
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.4.5]
Otis Judkins
d. 1994
12
Darren Leslie Judkins
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.4.5.1]
10
Theresa Anna Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.5]
b. 26 Jun 1916 d. 27 Jun 2002
Perry Thornberg
11
Perry "Pat" Thornberg
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.5.1]
b. 3 Jun 1933 d. 14 May 1996
Nancy Burleson
12
Perry Alexander "Alex" Thornberg
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.5.1.1]
[
=>
]
12
Julia Thornberg
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.5.1.2]
Theophilus "Sam" Wahrenberger
11
John Wahrenberger
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.5.2]
Susan Christmas
12
John Paul Wahrenberger
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.5.2.1]
12
Rebecca Wahrenberger
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.5.2.2]
+
Teri Hogenhaus
11
Sue Wahrenberger
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.5.3]
Jon A Lotz
12
Kimberly Linette "Kim" Lotz
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.5.3.1]
12
Diana Kathleen "Kat" Lotz
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.5.3.2]
11
Kenneth Wahrenberger
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.5.4]
+
Angela Lively
10
Charles Melvin Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.6]
b. 28 Jan 1919 d. 13 Dec 1979
Julia Mae Ledford
b. 19 May 1921 d. 5 Jun 2002
11
Charles Melvin Whipple, Jr
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.6.1]
Gwenneth Brown
b. 12 Feb 1941 d. 12 Dec 2010
12
Christian Von Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.6.1.1]
[
=>
]
12
Michelle Dyanne Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.6.1.2]
11
Johnny Marvin Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.6.2]
b. 3 Mar 1940 d. Nov 1940
11
Bobby Eugene Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.6.3]
Mary Screws
12
Christopher Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.6.3.1]
[
=>
]
12
Tonie Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.6.3.2]
[
=>
]
12
Debra Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.6.3.3]
[
=>
]
11
Jimmy Leroy Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.6.4]
Connie Rawlins
12
Pamala Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.6.4.1]
[
=>
]
12
Jimmy Mark Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.6.4.2]
[
=>
]
12
Ronnie Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.6.4.3]
12
Jerry Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.6.4.4]
[
=>
]
+
Debbie Raven
11
Julia Laverne "Judy" Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.6.5]
Gary Lee Webster
b. 1945 d. 1998
12
Gary Lee "Gordo" Webster, Jr
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.6.5.1]
[
=>
]
James Lowry
12
Justina Lowry
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.6.5.2]
[
=>
]
Phillip Suhre
b. 2 Feb 1951 d. 11 Feb 2000
12
Kelly Jo Suhre
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.6.5.3]
[
=>
]
11
Paul David Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.6.6]
Margaret Kukuk
12
Paul David Whipple, Jr
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.6.6.1]
12
Alexis Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.6.6.2]
11
Deborah Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.6.7]
Keith Miller
12
Jennifer Miller
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.6.7.1]
[
=>
]
12
Amy Miller
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.6.7.2]
[
=>
]
12
Bucky Miller
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.6.7.3]
[
=>
]
11
Linda Kathleen "Kathy" Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.6.8]
Michael Caliman
12
Amanda Caliman
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.6.8.1]
[
=>
]
12
Michael Caliman
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.6.8.2]
12
Derek Caliman
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.6.8.3]
12
Casandra Caliman
[1.7.6.4.16.6.1.6.7.6.8.4]
+
Adda Nimmo
b. Abt 1878 d. 1949
9
Mary Elizabeth Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.8]
b. 25 Nov 1875 d. 2 Jun 1965
+
Eldo E Underwood
b. Abt 1872 d. Aft 1893
Henry Joseph Countz Taylor
b. 29 Mar 1860 d. 31 Oct 1936
10
Amy Crystal Taylor
[1.7.6.4.16.6.1.6.8.1]
b. 11 Oct 1905 d. 4 Feb 1977
John Evans
b. Abt 1901
11
Paul Joseph Evans
[1.7.6.4.16.6.1.6.8.1.1]
b. 14 Jan 1932 d. 1964
9
John Milton Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.9]
b. 25 Nov 1875 d. Oct 1876
Amelia Ann "Mollie" Taylor Pavy
b. 12 Oct 1840 d. 2 Dec 1919
9
Emma Susan Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.6.10]
b. 28 Mar 1879 d. 18 Mar 1906
William Reed
b. Abt 1875 d. Abt 1905
10
Laura May Reed
[1.7.6.4.16.6.1.6.10.1]
b. 3 Jul 1896 d. 29 Jun 1967
+
Ellis R Hyde
b. Abt 1892
+
Garretson
b. Abt 1892
10
Alva T Reed
[1.7.6.4.16.6.1.6.10.2]
b. 5 Jul 1898 d. 15 Mar 1972
+
Cecelia Ember
b. 21 Jun 1898 d. 9 Nov 1963
8
Louise Angeline Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.7]
b. Abt 1837 d. Abt 1911
Robert Seeley
b. 23 Dec 1834
9
Elizabeth Seely
[1.7.6.4.16.6.1.7.1]
b. 1860
9
Levi Seely
[1.7.6.4.16.6.1.7.2]
b. 1860
9
William Alfred Seeley
[1.7.6.4.16.6.1.7.3]
b. 6 Dec 1862 d. 24 Sep 1948
Emma Elnora Collins
b. 26 Sep 1874 d. 18 Dec 1949
10
Herman V Seeley
[1.7.6.4.16.6.1.7.3.1]
b. 12 May 1906 d. 15 Sep 1985
LaVonne B Bradford
b. 7 Apr 1905 d. 30 Nov 1998
11
Living
[1.7.6.4.16.6.1.7.3.1.1]
11
Catherine Elnora Seeley
[1.7.6.4.16.6.1.7.3.1.2]
b. 6 Nov 1929 d. 6 Nov 1929
11
Living
[1.7.6.4.16.6.1.7.3.1.3]
10
Elizabeth A Seeley
[1.7.6.4.16.6.1.7.3.2]
b. 1908
10
Mettie Pearl Seeley
[1.7.6.4.16.6.1.7.3.3]
b. 1912
9
Frank Seely
[1.7.6.4.16.6.1.7.4]
b. 1865
9
Eva Seely
[1.7.6.4.16.6.1.7.5]
b. 1869
9
Emma Seely
[1.7.6.4.16.6.1.7.6]
b. 1875
Jacob S Smith
b. 1843 d. Abt 1875
9
Charlie Smith
[1.7.6.4.16.6.1.7.7]
b. Abt 1869
+
James B Underwood
b. Abt 1832 d. 14 Apr 1910
8
Elizabeth Ann Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.8]
b. 7 Jun 1839 d. 1 Aug 1918
Joseph Dales
b. Abt 1824 d. Abt 1909
9
Elizabeth Dales
[1.7.6.4.16.6.1.8.1]
b. Abt 1857
9
Lizzie Dales
[1.7.6.4.16.6.1.8.2]
b. Abt 1861
8
George Washington Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.9]
b. 10 May 1841 d. 1 Dec 1904
Angeline Wilson
b. Abt 1845 d. Aft 22 Mar 1922
9
Milly Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.9.1]
b. Abt 1867
9
Benjamin Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.9.2]
b. Abt 1869
+
Cora
b. Mar 1877
9
Milby E Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.9.3]
b. 1866
9
Elma Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.9.4]
b. Dec 1871 d. Aft 22 Mar 1922
9
George Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.9.5]
b. Oct 1882 d. Aft 7 May 1910
Alice Webster
b. Abt 1887 d. Aft 7 May 1910
10
George H Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.9.5.1]
+
Eugenia M M Carroll
8
Mary Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.10]
b. Abt 1843
8
Mortimer Murray Whipple
[1.7.6.4.16.6.1.11]
b. Abt 1844 d. Abt 1915
+
Sarah E Pettigrew
b. Abt 1854 d. Aft 1920
7
George Washington Whipple
[1.7.6.4.16.6.2]
b. 29 Apr 1809 d. 5 Sep 1879
Mary Susan Cottrell
b. Abt 1809 d. 19 Nov 1911
8
Cornelius Whipple
[1.7.6.4.16.6.2.1]
b. Abt 1842 d. 18 Mar 1909
Ester Adelaide Trainer
b. 1846
9
Carrie May Whipple
[1.7.6.4.16.6.2.1.1]
b. 1866
John M Hollowell
b. Abt 1866
10
Gertie B Hollowell
[1.7.6.4.16.6.2.1.1.1]
b. 18 Mar 1885 d. 6 Feb 1956
+
William Keene
b. 14 May 1885 d. 17 May 1934
9
George Whipple
[1.7.6.4.16.6.2.1.2]
b. 28 Jun 1870 d. 18 Jan 1924
Charlotte Marie Hahn
b. Abt 1876
10
Cornelius Charles Whipple
[1.7.6.4.16.6.2.1.2.1]
b. Abt 1893
Ethel Cassidy
b. Abt 1893
11
Robert Carl Whipple
[1.7.6.4.16.6.2.1.2.1.1]
b. 7 Feb 1915 d. Feb 1981
Mary Elfred Millerhaus
12
Robert Allen Whipple
[1.7.6.4.16.6.2.1.2.1.1.1]
b. 26 Jul 1935 d. 20 Oct 1979 [
=>
]
12
Wayne Martin Whipple
[1.7.6.4.16.6.2.1.2.1.1.2]
[
=>
]
11
Mildred Whipple
[1.7.6.4.16.6.2.1.2.1.2]
Robert Armstrong
12
Robert Armstrong
[1.7.6.4.16.6.2.1.2.1.2.1]
12
Nancy Armstrong
[1.7.6.4.16.6.2.1.2.1.2.2]
12
Karen Armstrong
[1.7.6.4.16.6.2.1.2.1.2.3]
10
Effie Whipple
[1.7.6.4.16.6.2.1.2.2]
b. Abt 1900
9
Rosa S Whipple
[1.7.6.4.16.6.2.1.3]
b. 8 Jun 1872 d. 20 Feb 1933
John Hahn
b. 21 Jun 1870 d. 14 Oct 1938
10
Pearl Ada Hahn
[1.7.6.4.16.6.2.1.3.1]
b. 12 Sep 1893 d. 25 Dec 1985
John Jacob Loos
b. 28 Oct 1892 d. 3 Mar 1937
11
Chester Loos
[1.7.6.4.16.6.2.1.3.1.1]
b. 14 Jun 1918 d. 14 Oct 1994
11
Lorene Pearl Loos
[1.7.6.4.16.6.2.1.3.1.2]
b. 31 Mar 1921 d. 23 Dec 1990
+
Henry Hollingsworth
b. 6 Sep 1916 d. 12 Feb 1982
10
Mina F Hahn
[1.7.6.4.16.6.2.1.3.2]
b. 11 Jan 1895 d. 19 Dec 1982
Charles Henry Waller
b. 30 Aug 1894 d. 5 Apr 1958
11
Minnie Rose Waller
[1.7.6.4.16.6.2.1.3.2.1]
b. 3 May 1921 d. 10 May 1993
+
Martin Baars
b. 19 Jul 1920 d. 24 Apr 1993
11
Avonda Belle "Vonnie" Waller
[1.7.6.4.16.6.2.1.3.2.2]
b. 5 Feb 1924 d. 15 Jul 1995
11
Leonard Waller
[1.7.6.4.16.6.2.1.3.2.3]
11
Lawrence Waller
[1.7.6.4.16.6.2.1.3.2.4]
11
Charles Henry Waller, Jr
[1.7.6.4.16.6.2.1.3.2.5]
10
Opal Hahn
[1.7.6.4.16.6.2.1.3.3]
b. 22 Jul 1898 d. 21 Jul 1967
George Gerngross
b. 21 Jun 1891 d. 30 Mar 1942
11
Leona Gerngross
[1.7.6.4.16.6.2.1.3.3.1]
b. 9 Dec 1923 d. 13 Sep 1995
11
Annalee Gerngross
[1.7.6.4.16.6.2.1.3.3.2]
10
Loretta "Retty" Hahn
[1.7.6.4.16.6.2.1.3.4]
b. 22 Jul 1898 d. 12 Jul 1967
William Handy
b. 25 Apr 1881 d. 28 Mar 1966
11
Orville Handy
[1.7.6.4.16.6.2.1.3.4.1]
10
Frances Hahn
[1.7.6.4.16.6.2.1.3.5]
b. 1903
11
Leroy Hahn
[1.7.6.4.16.6.2.1.3.5.1]
10
Ida Hahn
[1.7.6.4.16.6.2.1.3.6]
b. 1906 d. 1991
Harry Wilson
b. 1906 d. 1991
11
Donald Wilson
[1.7.6.4.16.6.2.1.3.6.1]
b. 25 Nov 1928 d. 4 Jun 1988
Dora Kraus
12
Gerald Wilson
[1.7.6.4.16.6.2.1.3.6.1.1]
b. 13 Oct 1950 d. 20 Jan 1992
12
Diane Wilson
[1.7.6.4.16.6.2.1.3.6.1.2]
12
Deane Wilson
[1.7.6.4.16.6.2.1.3.6.1.3]
12
Debbie Wilson
[1.7.6.4.16.6.2.1.3.6.1.4]
11
Shirley Wilson
[1.7.6.4.16.6.2.1.3.6.2]
Ralph Guenther
12
Vicki Guenther
[1.7.6.4.16.6.2.1.3.6.2.1]
11
Corabell Wilson
[1.7.6.4.16.6.2.1.3.6.3]
11
Larry Wilson
[1.7.6.4.16.6.2.1.3.6.4]
11
Herbie Wilson
[1.7.6.4.16.6.2.1.3.6.5]
10
Charles Hahn
[1.7.6.4.16.6.2.1.3.7]
b. 22 Dec 1911 d. Apr 1967
10
Omer John Hahn
[1.7.6.4.16.6.2.1.3.8]
b. 9 Oct 1912 d. 11 Jul 1991
Flora Jean Graves
b. 20 Dec 1915 d. 3 Jan 1994
11
Patsy Ometa Hahn
[1.7.6.4.16.6.2.1.3.8.1]
b. 15 Feb 1936 d. 8 Dec 1994
Larry Grubbs
12
Brent Joseph Grubbs
[1.7.6.4.16.6.2.1.3.8.1.1]
12
Sherri Lynn Grubbs
[1.7.6.4.16.6.2.1.3.8.1.2]
12
John Stacy Grubbs
[1.7.6.4.16.6.2.1.3.8.1.3]
11
Dennis Lee Hahn
[1.7.6.4.16.6.2.1.3.8.2]
Barbara Ann Bryant
b. 18 Aug 1939 d. 19 Dec 1972
12
Denise Ann Hahn
[1.7.6.4.16.6.2.1.3.8.2.1]
[
=>
]
12
Julia Elaine Hahn
[1.7.6.4.16.6.2.1.3.8.2.2]
[
=>
]
9
Frank Whipple
[1.7.6.4.16.6.2.1.4]
b. 1875 d. Abt 1945
Lizzie Wescot
b. 1886
10
Charlie Whipple
[1.7.6.4.16.6.2.1.4.1]
b. 20 Jun 1922 d. 30 Jun 1982
Beth
b. 1922 d. 1975
11
Frank Whipple
[1.7.6.4.16.6.2.1.4.1.1]
9
Loretta M "Retty" Whipple
[1.7.6.4.16.6.2.1.5]
b. 1877
George Hahn
b. Abt 1875 d. 30 Jan 1925
10
Ethel D Hahn
[1.7.6.4.16.6.2.1.5.1]
b. 1901 d. 1974
William Burgess
b. 2 Jun 1898 d. Jun 1986
11
Living
[1.7.6.4.16.6.2.1.5.1.1]
11
Allen Eugene "Bud" Burgess
[1.7.6.4.16.6.2.1.5.1.2]
b. 10 Feb 1925 d. 12 Dec 1986
11
Living
[1.7.6.4.16.6.2.1.5.1.3]
10
Ester A Hahn
[1.7.6.4.16.6.2.1.5.2]
b. 1903 d. Aft 30 Jan 1920
10
Philibina F Hahn
[1.7.6.4.16.6.2.1.5.3]
b. 1906 d. Aft 30 Jun 1920
9
Richard Whipple
[1.7.6.4.16.6.2.1.6]
b. 1879
Susan Rifner
b. 12 Apr 1829 d. 22 Jan 1913
8
Mary Ella Whipple
[1.7.6.4.16.6.2.2]
b. 1859 d. 1947
+
William R Stewart
b. Abt 1859
8
Abner L Whipple
[1.7.6.4.16.6.2.3]
b. 3 Dec 1861 d. 15 Feb 1936
+
Felicia W "Lessie" Gurr
b. Abt 1861
8
Ida Belle Whipple
[1.7.6.4.16.6.2.4]
b. 6 May 1864 d. 13 Feb 1938
Charles C Crouse
b. 18 Jun 1863 d. 26 May 1936
9
Gladys Marie Crouse
[1.7.6.4.16.6.2.4.1]
b. 1895
+
Paul Willis Moffett
b. 23 Apr 1893
9
George Russel Crouse
[1.7.6.4.16.6.2.4.2]
b. 29 Jun 1896 d. 12 Jul 1947
Ruby May Bishop
b. 29 Nov 1896 d. 22 Sep 1944
10
Janice Crouse
[1.7.6.4.16.6.2.4.2.1]
b. 10 May 1927 d. 13 May 2015
10
Carolyn June Crouse
[1.7.6.4.16.6.2.4.2.2]
b. 10 May 1927 d. Bef 13 May 1915
8
William Cornelius Whipple
[1.7.6.4.16.6.2.5]
b. 4 May 1867 d. 7 May 1940
Edith Hennrietta Stoops
b. 29 Jan 1863
9
Dorothy E Whipple
[1.7.6.4.16.6.2.5.1]
b. 8 Oct 1898 d. Jun 1975
+
Russell Suttles
b. 2 Sep 1895 d. 17 Jan 1990
9
William Stoops Whipple
[1.7.6.4.16.6.2.5.2]
b. 8 Mar 1900 d. 10 May 1945
+
Jessie
b. 29 Nov 1898 d. 22 Sep 1996
9
Mary Arnold Whipple
[1.7.6.4.16.6.2.5.3]
8
John E Whipple
[1.7.6.4.16.6.2.6]
b. 1868 d. 29 Apr 1955
+
Grace Bell Edwards
b. 15 Jan 1883 d. 27 Nov 1960
8
Martha M Whipple
[1.7.6.4.16.6.2.7]
b. 1872
8
May Elizabeth Whipple
[1.7.6.4.16.6.2.8]
b. 30 Jun 1874 d. 7 Jan 1930
+
John Ryan
b. Abt 1874
8
George Seneca Whipple
[1.7.6.4.16.6.2.9]
b. 3 Aug 1877 d. 31 Aug 1937
Ida Myrtle Stephens
b. 13 Sep 1886 d. 18 Nov 1918
9
Jeanetta Ruth Whipple
[1.7.6.4.16.6.2.9.1]
b. 3 Aug 1905 d. 29 Jan 1953
Charles Phillip Roome
b. 4 Jan 1903 d. 7 Mar 1954
10
Anna Laura "Ann" Roome
[1.7.6.4.16.6.2.9.1.1]
b. 23 Aug 1924 d. 2 Sep 2013
William Edwin Lahr
b. 3 Jan 1921 d. 28 Oct 1979
11
Joseph Martini Lahr
[1.7.6.4.16.6.2.9.1.1.1]
+
Yayoi
11
Joanne Lahr
[1.7.6.4.16.6.2.9.1.1.2]
10
Mary Maxine Roome
[1.7.6.4.16.6.2.9.1.2]
b. 6 Aug 1927 d. 2 Feb 1972
10
Aurthur Eugene Roome
[1.7.6.4.16.6.2.9.1.3]
b. Jul 1929 d. 29 Sep 1929
10
Virginia Lucille Roome
[1.7.6.4.16.6.2.9.1.4]
b. 13 Sep 1934 d. 26 May 1989
10
Juanita Roome
[1.7.6.4.16.6.2.9.1.5]
10
Phyllis Roome
[1.7.6.4.16.6.2.9.1.6]
10
Jean Roome
[1.7.6.4.16.6.2.9.1.7]
9
Lillian Luella Whipple
[1.7.6.4.16.6.2.9.2]
b. 8 Feb 1908 d. 13 Mar 1994
+
Thomas Gruell
b. Abt 1908
9
Paul George Les Whipple
[1.7.6.4.16.6.2.9.3]
b. 10 May 1910 d. 3 Jun 1941
9
Bertha Lucille Whipple
[1.7.6.4.16.6.2.9.4]
b. 13 Jun 1912 d. 7 May 1928
9
James Eugene Whipple
[1.7.6.4.16.6.2.9.5]
b. 14 Aug 1915 d. 9 Oct 1993
+
Living
Living
10
James Thomas Whipple
[1.7.6.4.16.6.2.9.5.1]
Michelle
11
James Michael Eugene Whipple
[1.7.6.4.16.6.2.9.5.1.1]
9
Joseph Franklin Whipple
[1.7.6.4.16.6.2.9.6]
b. Nov 1918 d. 28 Jan 1919
7
Maribah "Mary" Whipple
[1.7.6.4.16.6.3]
b. 7 May 1811 d. 9 May 1876
Joel Mann
b. Abt 1811 d. 29 May 1879
8
Nathaniel Mann
[1.7.6.4.16.6.3.1]
b. Nov 1833 d. 23 Dec 1922
Margaret Lambert
b. 1834 d. Abt 1875
9
Lillian Mann
[1.7.6.4.16.6.3.1.1]
b. 20 May 1858 d. 19 Dec 1929
Daniel Cawein
b. 13 May 1854 d. 10 Oct 1918
10
Maggie May Cawein
[1.7.6.4.16.6.3.1.1.1]
b. 1 May 1877 d. 24 Mar 1937
+
Jesse S Tucker
b. 2 Apr 1882
10
Augustus Isom Cawein
[1.7.6.4.16.6.3.1.1.2]
b. Sep 1879 d. Nov 1948
+
Stella Alexander
b. 19 Jul 1880
10
Lennie Anna Cawein
[1.7.6.4.16.6.3.1.1.3]
b. Jul 1881
John Carter
d. 13 Nov 1901
11
Hazel Sebina Carter
[1.7.6.4.16.6.3.1.1.3.1]
b. 4 Nov 1899
+
Owen S Parker
Charley Leroy Readle
11
Joseph Leroy Readle
[1.7.6.4.16.6.3.1.1.3.2]
b. 13 Jul 1907
+
Opal Ends
b. 5 Mar 1909
+
Charles Bundy
b. 9 Jan 1880
10
Elbert P Cawein
[1.7.6.4.16.6.3.1.1.4]
b. 23 Oct 1882 d. 12 Oct 1961
May Blanche Kennedy
b. 21 Jun 1884
11
Mildred Lucille Cawein
[1.7.6.4.16.6.3.1.1.4.1]
b. 21 Apr 1905
+
John Gardner
b. 11 Aug 1901
11
Mabel Luree Cawein
[1.7.6.4.16.6.3.1.1.4.2]
b. 11 May 1906
+
Earnest Addison
b. 20 Jun 1902
11
Helen Cawein
[1.7.6.4.16.6.3.1.1.4.3]
b. 12 Dec 1910
+
Delmas White
b. 11 Feb 1907
11
Living
[1.7.6.4.16.6.3.1.1.4.4]
+
Living
10
George Cawein
[1.7.6.4.16.6.3.1.1.5]
b. 15 Jan 1885
+
Blanch Downey
b. 23 Aug 1889
10
Ethel Cawein
[1.7.6.4.16.6.3.1.1.6]
b. 16 Jun 1890
9
Mary L Mann
[1.7.6.4.16.6.3.1.2]
b. Apr 1860
9
George Washington McClellan Mann
[1.7.6.4.16.6.3.1.3]
b. Oct 1862
Ida Etta Jones
b. Jun 1865
10
Orrie E Mann
[1.7.6.4.16.6.3.1.3.1]
b. Feb 1885
10
Jessie M Mann
[1.7.6.4.16.6.3.1.3.2]
b. Dec 1890
8
Anna Mann
[1.7.6.4.16.6.3.2]
b. Abt 1835
George Otis Mosher
b. 4 Mar 1833 d. 13 Mar 1874
9
Carrie Condit Mosher
[1.7.6.4.16.6.3.2.1]
b. 26 Jun 1860 d. 8 Nov 1895
9
Caroline C Mosher
[1.7.6.4.16.6.3.2.2]
b. 26 Jun 1861
9
Gertrude E Mosher
[1.7.6.4.16.6.3.2.3]
b. Feb 1863 d. 8 Nov 1877
9
Harriet Mosher
[1.7.6.4.16.6.3.2.4]
b. 1865 d. 1874
9
Sarah F Mosher
[1.7.6.4.16.6.3.2.5]
b. 28 Sep 1867
9
Hattie C Mosher
[1.7.6.4.16.6.3.2.6]
b. 2 May 1869
9
Abbie Mosher
[1.7.6.4.16.6.3.2.7]
b. 26 Jul 1870
9
Hugh Mosher
[1.7.6.4.16.6.3.2.8]
b. Jan 1874 d. Feb 1874
8
Polly Mann
[1.7.6.4.16.6.3.3]
b. Abt 1835
8
Jonathan Mann
[1.7.6.4.16.6.3.4]
b. Abt 1836
8
Ormand Mann
[1.7.6.4.16.6.3.5]
b. Abt 1838
+
Mary Redford
b. Abt 1838
8
George Mann
[1.7.6.4.16.6.3.6]
b. Abt 1839
8
Persa Mann
[1.7.6.4.16.6.3.7]
b. Abt 1841
8
Persey Mann
[1.7.6.4.16.6.3.8]
b. May 1844
Charles M Seely
b. Sep 1832
9
John W Seeley
[1.7.6.4.16.6.3.8.1]
b. 1869
Tilly Nagle
b. Jul 1879
10
Ceicel Seeley
[1.7.6.4.16.6.3.8.1.1]
b. May 1899
9
Jacob Seeley
[1.7.6.4.16.6.3.8.2]
b. Mar 1872
9
Jesse Seely
[1.7.6.4.16.6.3.8.3]
b. Mar 1874
Cora Francis Thomas
b. Sep 1874
10
Lowell Seely
[1.7.6.4.16.6.3.8.3.1]
b. 1900
9
Fedella Seeley
[1.7.6.4.16.6.3.8.4]
b. 1877
9
Eliza Emline Seely
[1.7.6.4.16.6.3.8.5]
b. 1879
+
Raymond Taylor
b. Mar 1876
9
Louisa E Seeley
[1.7.6.4.16.6.3.8.6]
b. Aug 1881
9
Andrew Jackson Seeley
[1.7.6.4.16.6.3.8.7]
b. Mar 1884
8
Eliza Mann
[1.7.6.4.16.6.3.9]
b. 7 Aug 1845 d. 15 Jun 1922
Esa Larimore
b. 30 May 1839 d. 7 Sep 1906
9
John Nelson Larmore
[1.7.6.4.16.6.3.9.1]
b. 24 Oct 1866 d. 28 Nov 1946
Flora Jane Carter
b. 31 Jul 1869 d. 17 Mar 1946
10
Minnie Alta Larmore
[1.7.6.4.16.6.3.9.1.1]
b. 9 Dec 1887 d. 4 Mar 1918
Fritz Clarence Waeltz
b. 23 Aug 1881 d. 2 Oct 1963
11
Henry N Waeltz
[1.7.6.4.16.6.3.9.1.1.1]
b. 7 Feb 1903 d. 3 Feb 1968
11
Clarence Edward "Zebe" Waeltz
[1.7.6.4.16.6.3.9.1.1.2]
b. 30 Apr 1905 d. 10 Sep 1993
+
Adeline Lenora "Babe" Watson
b. 7 Oct 1907 d. 3 Jul 2001
11
Verdelia Waeltz
[1.7.6.4.16.6.3.9.1.1.3]
b. 18 Feb 1907 d. 27 Feb 1978
+
Miles Lawrence Anderson
11
Reba H Waeltz
[1.7.6.4.16.6.3.9.1.1.4]
b. 18 Oct 1909 d. 17 Jan 1994
11
Genevieve Fern Waeltz
[1.7.6.4.16.6.3.9.1.1.5]
b. 27 Apr 1914 d. 10 Apr 1978
Lester Shock
b. 13 Jul 1912 d. Oct 1977
12
Lester Raymond Shock
[1.7.6.4.16.6.3.9.1.1.5.1]
b. 19 Jun 1935 d. 22 May 1999
12
Charles Frederick Shock
[1.7.6.4.16.6.3.9.1.1.5.2]
b. 26 Jul 1936 d. 11 Aug 1936
12
Neva Mae Shock
[1.7.6.4.16.6.3.9.1.1.5.3]
b. 31 Mar 1938 d. 31 Mar 1938
12
Geneva Shock
[1.7.6.4.16.6.3.9.1.1.5.4]
b. 31 Mar 1938 d. 31 Mar 1938
12
Jerry Lee Shock
[1.7.6.4.16.6.3.9.1.1.5.5]
b. 21 May 1944 d. 1 Feb 1998
12
Dixie Lee Shock
[1.7.6.4.16.6.3.9.1.1.5.6]
b. 11 Jun 1946 d. 11 Jun 1946
10
Oliver Marion Larmore
[1.7.6.4.16.6.3.9.1.2]
b. 1889 d. 1968
Clora Ethel Potter
b. 1890
11
Genevieve Marion Larmore
[1.7.6.4.16.6.3.9.1.2.1]
b. 29 Nov 1921 d. 6 Aug 1987
Lloyd Marvin Eagan
b. 5 Jan 1904 d. 2 Oct 1979
12
Mary Ruth Eagan
[1.7.6.4.16.6.3.9.1.2.1.1]
b. 24 Mar 1941 d. 14 Dec 2001
12
Sharon Marlene Eagan
[1.7.6.4.16.6.3.9.1.2.1.2]
b. 14 Dec 1950 d. 18 Dec 2005
10
Eliza Larmore
[1.7.6.4.16.6.3.9.1.3]
b. May 1892
10
Joseph Esau Larmore
[1.7.6.4.16.6.3.9.1.4]
b. 1893 d. 1893
10
Era Evelyn Larmore
[1.7.6.4.16.6.3.9.1.5]
b. 1894
10
Iva Mae Larmore
[1.7.6.4.16.6.3.9.1.6]
b. 30 Jun 1896 d. 28 May 1938
William Conrad Hast
b. 31 Dec 1892 d. 6 Jul 1972
11
Harold Hast
[1.7.6.4.16.6.3.9.1.6.1]
b. 1916 d. 1934
11
Goldie Lorene Hast
[1.7.6.4.16.6.3.9.1.6.2]
b. 23 Aug 1917 d. 27 Feb 2000
Clifton Doyel Winder
b. 17 May 1909 d. 7 May 1982
12
Lee Roy Winder
[1.7.6.4.16.6.3.9.1.6.2.1]
b. 8 Aug 1938 d. 26 Apr 2011
12
William Ray Winder
[1.7.6.4.16.6.3.9.1.6.2.2]
b. 12 Dec 1940 d. 19 Jun 1998
12
James Edward Winder
[1.7.6.4.16.6.3.9.1.6.2.3]
b. 2 Feb 1942 d. 7 Mar 1966
12
John Wayne Winder
[1.7.6.4.16.6.3.9.1.6.2.4]
b. 3 Dec 1951 d. 4 Feb 1952
12
Barbara Lou Winder
[1.7.6.4.16.6.3.9.1.6.2.5]
b. 18 Apr 1954 d. 29 Jun 1954
11
Johnny Adam Hast
[1.7.6.4.16.6.3.9.1.6.3]
b. 15 Jan 1922 d. 20 Mar 1978
11
Clois Eugene Hast
[1.7.6.4.16.6.3.9.1.6.4]
b. 19 Dec 1929 d. 31 Mar 2001
11
Doris Dean Hast
[1.7.6.4.16.6.3.9.1.6.5]
b. Apr 1938 d. Apr 1938
10
Nona Marie Larmore
[1.7.6.4.16.6.3.9.1.7]
b. 22 Apr 1898 d. 6 Oct 1962
Everett Hern Elder
b. 28 Apr 1898 d. 29 Jun 1966
11
Jesse Carl Elder
[1.7.6.4.16.6.3.9.1.7.1]
b. 22 Nov 1921 d. 2 Apr 1998
11
Clois Eugene Elder
[1.7.6.4.16.6.3.9.1.7.2]
b. 4 Dec 1924 d. 11 Jan 1995
11
Billy Hern Elder
[1.7.6.4.16.6.3.9.1.7.3]
b. 1928 d. 1987
11
Wilma Jean Elder
[1.7.6.4.16.6.3.9.1.7.4]
b. 22 Oct 1929 d. 21 Jan 2011
Clarence Cecil Brent
b. 12 May 1929 d. 28 Apr 2014
12
Danny Wayne Brent
[1.7.6.4.16.6.3.9.1.7.4.1]
b. 3 Apr 1952 d. 21 Jul 2013
11
Chester Elsworth Elder
[1.7.6.4.16.6.3.9.1.7.5]
b. 1932 d. 1985
10
Johnny Larmore
[1.7.6.4.16.6.3.9.1.8]
b. Feb 1899 d. Sep 1899
10
Elza Leverall Larmore
[1.7.6.4.16.6.3.9.1.9]
b. 3 Apr 1901 d. 16 Mar 1918
9
Ann Larmore
[1.7.6.4.16.6.3.9.2]
b. 1868
9
Mary Ellen Larmore
[1.7.6.4.16.6.3.9.3]
b. 1872
9
Mary Elizabeth Larimore
[1.7.6.4.16.6.3.9.4]
b. 11 Jan 1875 d. 7 Jul 1926
William Elbert Nagle
b. 11 Mar 1872 d. 10 Dec 1922
10
Johnnie Nelson Nagle
[1.7.6.4.16.6.3.9.4.1]
b. 27 Feb 1886 d. 2 Sep 1896
10
Golden Dewey Nagle
[1.7.6.4.16.6.3.9.4.2]
b. 29 May 1898 d. 17 Jan 1962
+
Lela Beatrice Herod
b. Abt 1902
10
Leon Elbert Nagle
[1.7.6.4.16.6.3.9.4.3]
b. 19 Apr 1900 d. 7 Apr 1919
10
Olive Naomi Nagle
[1.7.6.4.16.6.3.9.4.4]
b. 14 Mar 1903 d. 14 Aug 1937
Andrew Dunn
b. 18 Nov 1883 d. 3 Oct 1948
11
Jewel Andy Dunn
[1.7.6.4.16.6.3.9.4.4.1]
b. 14 Nov 1924 d. 11 Jan 1985
+
John Thomas Owens
b. Abt 1920 d. 5 Sep 1990
11
Ida Bell Dunn
[1.7.6.4.16.6.3.9.4.4.2]
b. 23 Dec 1928 d. 10 Dec 2000
Robert Bolen Moseley
b. Abt 1924 d. 6 Jul 1992
12
James Robertson Moseley
[1.7.6.4.16.6.3.9.4.4.2.1]
b. Sep 1948 d. 11 Mar 1949
11
Callie Wilma Dunn
[1.7.6.4.16.6.3.9.4.4.3]
b. 24 Jul 1930 d. 9 May 2007
+
Charlie Walker Jarrell
b. 30 Jun 1929 d. 16 Mar 2009
11
William Columbus Dunn
[1.7.6.4.16.6.3.9.4.4.4]
b. 22 Feb 1932 d. 27 Mar 2000
+
Deanna Jean Schrader
b. 28 Jul 1939 d. 22 Aug 2007
10
Gladys Valley Nagle
[1.7.6.4.16.6.3.9.4.5]
b. 5 Mar 1905 d. 25 Jul 1957
+
Tom Radford
b. Abt 1901
+
M Boyd Locke
b. Abt 1901
10
Raymond Edwin Nagle
[1.7.6.4.16.6.3.9.4.6]
b. 12 May 1910 d. 15 Dec 1991
+
Mary Agnes Smallwood
b. 29 Aug 1905 d. 27 Sep 1970
9
John Larrimore
[1.7.6.4.16.6.3.9.5]
b. Abt 1877
9
Ella Larrimore
[1.7.6.4.16.6.3.9.6]
b. Abt 1879
8
Jesse Mann
[1.7.6.4.16.6.3.10]
b. Abt 1848 d. 20 Mar 1931
Cynthia Ann Ward
b. 1852
9
Ada M Mann
[1.7.6.4.16.6.3.10.1]
b. Aug 1878
William Francis Boldrey
b. 3 Apr 1874
10
Effie Boldrey
[1.7.6.4.16.6.3.10.1.1]
b. Jun 1899 d. Bef 1910
10
Annie E Boldrey
[1.7.6.4.16.6.3.10.1.2]
b. 1901
10
William Jesse Boldrey
[1.7.6.4.16.6.3.10.1.3]
b. 7 Sep 1904 d. 11 Nov 1994
+
Rose Mae Jones
b. 7 Jan 1906 d. 9 Mar 1986
10
Josie Boldrey
[1.7.6.4.16.6.3.10.1.4]
b. 1905 d. Bef 1910
10
Robert Boldrey
[1.7.6.4.16.6.3.10.1.5]
b. 25 Feb 1912 d. Dec 1983
+
Margaret Gibson
b. 4 Oct 1917 d. 22 Nov 1990
10
Joseph Eli Boldrey
[1.7.6.4.16.6.3.10.1.6]
b. 14 Oct 1914 d. 4 Mar 2002
+
June Retherford
b. 23 Jun 1918 d. 9 Nov 2007
9
Pearl Mae Mann
[1.7.6.4.16.6.3.10.2]
b. 1880 d. 1880
Emma E Sheppard
b. Jan 1880 d. 1900
9
Rosetta Mann
[1.7.6.4.16.6.3.10.3]
b. Oct 1896
+
Robert C Flocken
b. Apr 1872
9
Mary Mann
[1.7.6.4.16.6.3.10.4]
b. Sep 1898
Nancy Ann Coffman
b. 1859 d. 1895
9
Myrtie Mann
[1.7.6.4.16.6.3.10.5]
b. 1888 d. 1888
9
Bertie Mann
[1.7.6.4.16.6.3.10.6]
b. 1888 d. 1888
8
Susan Mann
[1.7.6.4.16.6.3.11]
b. 1851
8
Nancy Mann
[1.7.6.4.16.6.3.12]
b. 1853
7
Arnold John Whipple
[1.7.6.4.16.6.4]
b. 13 Nov 1813 d. 13 Apr 1882
Rebecca K Kennedy
b. Abt 1817 d. 26 Aug 1859
8
William Jefferson Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.1]
b. 28 Sep 1836 d. 7 Aug 1922
Martha Ellen Naylor
b. 20 Aug 1842 d. 10 Apr 1921
9
Ida Mae Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.1.1]
b. 18 Jul 1861 d. 6 Oct 1920
Frank E Moss
b. Jun 1862
10
Charles E Moss
[1.7.6.4.16.6.4.1.1.1]
b. Jan 1883
10
John William Moss
[1.7.6.4.16.6.4.1.1.2]
b. 10 Jan 1884
10
George Raymond Moss
[1.7.6.4.16.6.4.1.1.3]
b. 15 Jun 1885
10
Harry Dwight Moss
[1.7.6.4.16.6.4.1.1.4]
b. Apr 1888
Lottie May Teaford
b. May 1889
11
Harold James Moss
[1.7.6.4.16.6.4.1.1.4.1]
b. 2 Apr 1910 d. 21 Oct 1995
11
Helen Eloise Moss
[1.7.6.4.16.6.4.1.1.4.2]
b. 14 Sep 1915 d. 17 Dec 1990
11
Living
[1.7.6.4.16.6.4.1.1.4.3]
9
Jennie Belle Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.1.2]
b. 8 Mar 1863 d. 21 Nov 1938
Robert Adonija Harper
b. 22 Apr 1861 d. 14 Jun 1942
10
Ruby Belle Harper
[1.7.6.4.16.6.4.1.2.1]
b. 23 May 1884 d. 2 Jul 1923
10
Charles William Floyd Harper
[1.7.6.4.16.6.4.1.2.2]
b. 6 Jun 1889 d. 13 Jan 1968
+
Ann C Bullen
b. Abt 1891
10
Vera May Harper
[1.7.6.4.16.6.4.1.2.3]
b. 26 Feb 1892
10
Frances Vivian Harper
[1.7.6.4.16.6.4.1.2.4]
b. 17 Jan 1897
10
Robert Whipple Harper
[1.7.6.4.16.6.4.1.2.5]
b. 19 Aug 1906 d. 18 May 1973
9
Carrie Leota Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.1.3]
b. 14 Sep 1865 d. 31 May 1946
David Moss Davis
b. 5 Jan 1859 d. 12 Apr 1927
10
Edith Davis
[1.7.6.4.16.6.4.1.3.1]
b. 31 Jul 1884
10
Helen B Davis
[1.7.6.4.16.6.4.1.3.2]
b. 3 Jul 1888
10
Lee Moss Davis
[1.7.6.4.16.6.4.1.3.3]
b. 30 Jun 1890 d. 23 Jan 1969
Cora Alberta Whisler
b. 7 Feb 1894 d. 9 Jul 1987
11
Norvin Lee Davis
[1.7.6.4.16.6.4.1.3.3.1]
b. 28 Feb 1916 d. 6 Feb 1970
11
Living
[1.7.6.4.16.6.4.1.3.3.2]
11
Helen Virginia Davis
[1.7.6.4.16.6.4.1.3.3.3]
b. 3 May 1921 d. 8 May 2004
John Petroskie
b. 21 Mar 1922 bur. 5 Aug 1974
12
Donna Marie Petroskie
[1.7.6.4.16.6.4.1.3.3.3.1]
b. 28 Jul 1948 d. 31 Mar 2012
11
Marion Francis Davis
[1.7.6.4.16.6.4.1.3.3.4]
b. 13 Dec 1927 d. 13 Jan 2000
10
David Roy Davis
[1.7.6.4.16.6.4.1.3.4]
b. 30 Apr 1893
10
Francis Herbert Davis
[1.7.6.4.16.6.4.1.3.5]
b. 13 Dec 1903 d. 13 Oct 2003
+
Mary Lenora Beeson
b. 18 Dec 1908 d. 21 Jan 1998
9
William Franklin Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.1.4]
b. 29 Apr 1868 d. 8 May 1920
+
Sadie Sanborn
9
Charles Edward Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.1.5]
b. 5 Aug 1871 d. 5 Jun 1939
Laura Viola "Lulu" Clark
b. 28 Sep 1877 d. 28 Jun 1972
10
Mabel Blanche Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.1.5.1]
b. 25 Sep 1897 d. 10 Aug 1979
+
Earl Gwinrup
b. 6 Aug 1898
10
Nellie Mae Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.1.5.2]
b. 10 Sep 1899 d. 6 Oct 1920
+
Howard Linton Handley
b. 7 May 1898 d. 1 Apr 1970
+
Hollis Holmes
b. 25 Mar 1900 d. Oct 1984
10
William Russell Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.1.5.3]
b. 30 Nov 1904 d. 24 Jun 1971
Marion Dorothy Gibson
b. 12 Sep 1910 d. 8 Mar 2006
11
James Robert Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.1.5.3.1]
Linda Miller
12
Jama Anne Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.1.5.3.1.1]
[
=>
]
Phyllis Joy Bills
12
Cindy Jo Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.1.5.3.1.2]
12
James Russel Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.1.5.3.1.3]
12
Patricia Jane Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.1.5.3.1.4]
11
Lillian Mae Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.1.5.3.2]
Lloyd Keith Elmore
12
Marcia Elaine Elmore
[1.7.6.4.16.6.4.1.5.3.2.1]
12
Frank Allen Elmore
[1.7.6.4.16.6.4.1.5.3.2.2]
12
Dixie Darlene Elmore
[1.7.6.4.16.6.4.1.5.3.2.3]
12
Kenneth Wayne Elmore
[1.7.6.4.16.6.4.1.5.3.2.4]
11
Beatrice Viola Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.1.5.3.3]
b. 3 May 1930 d. 24 Sep 2005
+
Roy Abrams
11
Marion Russel Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.1.5.3.4]
b. 27 Mar 1933 d. 28 Jun 1940
11
Carolyn Sue Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.1.5.3.5]
Fredie Tyrone Netherly
12
Douglas Scott Netherly
[1.7.6.4.16.6.4.1.5.3.5.1]
12
Melissa Sue Netherly
[1.7.6.4.16.6.4.1.5.3.5.2]
12
Timothy Tyrone Netherly
[1.7.6.4.16.6.4.1.5.3.5.3]
11
Glenda Kay Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.1.5.3.6]
Charles Tanksley
12
Charles Andrew Tanksley
[1.7.6.4.16.6.4.1.5.3.6.1]
b. 15 Jan 1963 d. 12 Jul 1997
12
Dana Kay Tanksley
[1.7.6.4.16.6.4.1.5.3.6.2]
12
Donna Marie Tanksley
[1.7.6.4.16.6.4.1.5.3.6.3]
+
Oscar Gale Wheeler
Des Simmermon
12
Brandon Simmermon
[1.7.6.4.16.6.4.1.5.3.6.4]
12
Derek Simmermon
[1.7.6.4.16.6.4.1.5.3.6.5]
12
Tracy Ann Simmermon
[1.7.6.4.16.6.4.1.5.3.6.6]
+
Bill Lee
10
Clarence Earl Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.1.5.4]
b. Abt 1908
Myrtle Virginia Banks
11
Clarence Earl Whipple, Jr
[1.7.6.4.16.6.4.1.5.4.1]
Mary
12
Lucinea Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.1.5.4.1.1]
12
Melanie Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.1.5.4.1.2]
11
Marylyn Jean Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.1.5.4.2]
+
Roger Smith
10
Charles Joseph Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.1.5.5]
b. 2 Jan 1911 d. 2 Apr 1983
Helen Delores Purcell
b. 7 Mar 1913 d. 22 Jul 1988
11
Norman Gene Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.1.5.5.1]
b. 23 Sep 1932 d. 30 Jan 2010
Phyllis Ann Brown
12
Gary Gene Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.1.5.5.1.1]
12
Terry Lee Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.1.5.5.1.2]
11
Sandra Kay Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.1.5.5.2]
Robert Grove
12
Michael Brent Grove
[1.7.6.4.16.6.4.1.5.5.2.1]
12
Angela Lynn Grove
[1.7.6.4.16.6.4.1.5.5.2.2]
11
Charles Noel Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.1.5.5.3]
+
Mary Lou Beaver
+
Wilma Suanner
+
Betty Craven
9
Mattie Annie Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.1.6]
b. 9 Jan 1874 d. 3 Aug 1886
9
Rolland Watson Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.1.7]
b. 23 May 1876
9
Son Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.1.8]
b. 5 Feb 1879 d. 5 Feb 1879
9
Raymond Robert Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.1.9]
b. 23 Aug 1880 d. 27 Feb 1950
Nellie Viola Smith
b. 24 Dec 1882 d. 24 Jun 1912
10
Dorothy Marie Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.1.9.1]
b. 23 Apr 1904 d. 12 Jan 1992
Charles Patterson
b. 22 Feb 1899 d. 27 Dec 1964
11
Donald Clifford Patterson
[1.7.6.4.16.6.4.1.9.1.1]
b. 1 Jul 1921 d. 31 Jan 2003
Helen Stal
b. 2 May 1925 d. 24 Nov 1950
12
Child Patterson
[1.7.6.4.16.6.4.1.9.1.1.1]
b. Nov 1950 d. Nov 1950
11
Violet Marie Patterson
[1.7.6.4.16.6.4.1.9.1.2]
b. 5 Oct 1922
+
Aaron David Metz
b. 7 Jul 1917 d. 28 Dec 2010
11
Mary Dorothy Patterson
[1.7.6.4.16.6.4.1.9.1.3]
b. 18 Nov 1923 d. 11 Feb 1995
+
James William Howie
b. 1 Dec 1924 d. 12 Feb 1996
11
Charles Robert Patterson
[1.7.6.4.16.6.4.1.9.1.4]
b. 10 Dec 1924 d. 17 Aug 1926
11
Laura Ruth Patterson
[1.7.6.4.16.6.4.1.9.1.5]
b. 1 Jun 1927 d. 25 Oct 2005
+
George Willard Manuel
b. 9 Jun 1925 d. 18 Sep 1976
11
Paul Joseph Patterson
[1.7.6.4.16.6.4.1.9.1.6]
b. 26 Apr 1931 d. 13 Dec 2000
9
Klurie Naylor Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.1.10]
b. 26 Oct 1885
8
Isabel Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.2]
b. Abt 1844
8
Mary Elizabeth Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.3]
b. 1846
William Seely
b. Abt 1842 d. Aft 1868
9
Samuel L Seely
[1.7.6.4.16.6.4.3.1]
b. 12 Jan 1868 d. 24 Jan 1868
8
Joseph J Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.4]
b. 30 Sep 1848 d. 12 Sep 1927
Martha Emaline Bowlin
b. 26 Jan 1848 d. 3 Sep 1877
9
Lizzie Myrtle Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.4.1]
b. 1875
9
Joseph Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.4.2]
b. Mar 1877 d. 12 Sep 1877
8
William John Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.5]
b. Abt 1852 d. Aft 1878
+
Mary Ann Buffington
b. 5 Dec 1853 d. 3 Aug 1926
8
Thomas Franklin Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.6]
b. Oct 1853
Margaret Van Horn
b. 20 Feb 1864 d. 16 Mar 1956
9
Alice Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.6.1]
b. 17 Nov 1886 d. 7 Jan 1977
John William Seyfer
b. 13 Jun 1890 d. 12 Mar 1959
10
Dorothea Eileen Seyfer
[1.7.6.4.16.6.4.6.1.1]
b. 1 Jun 1916 d. 10 Feb 2002
+
James Glen Niday
b. 19 Mar 1911 d. 2 Mar 1971
9
Ralph Waldo Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.6.2]
b. 20 Nov 1889 d. 22 Jan 1972
Blanche Gertrude Maxwell
b. 16 Dec 1892 d. 9 Mar 1920
10
Yetive B C Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.6.2.1]
b. 8 Jan 1916 d. 4 Mar 2009
Clifford Anders Jacobsen
b. 19 Sep 1915 d. 15 Feb 1997
11
Gary Lee Jacobsen
[1.7.6.4.16.6.4.6.2.1.1]
b. 26 Feb 1938 d. 3 Mar 1967
10
Lorraine E Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.6.2.2]
b. 13 Dec 1918 d. 14 Dec 2011
+
Lavern Riese
b. 18 Oct 1917 d. 3 Mar 2003
9
Ruth Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.6.3]
b. Sep 1892
+
Edward I Troeger
b. 1897
9
Loudore Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.6.4]
b. Feb 1896
Florence Marie Fields
b. 7 Mar 1902 d. 21 Nov 1971
10
Walter Ashton Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.6.4.1]
b. 6 Sep 1923 d. 10 Dec 1930
9
Nora Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.6.5]
b. Oct 1897
9
Paul Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.6.6]
b. Feb 1900
8
Edward A Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.7]
b. Abt 1857
Mary A Carter
b. 18 Apr 1860 d. 9 Nov 1948
9
Ernest Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.7.1]
b. 1893 d. 13 Feb 1917
9
Earl John Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.7.2]
b. 3 Mar 1894 d. 1967
9
Edward Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.7.3]
b. 1897 d. 12 Jul 1915
8
George Washington Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.8]
b. 10 May 1841 d. 1 Dec 1904
Angeline Wilson
b. Abt 1845 d. Aft 22 Mar 1922
9
Milly Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.8.1]
b. Abt 1867
9
Benjamin Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.8.2]
b. Abt 1869
+
Cora
b. Mar 1877
9
Milby E Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.8.3]
b. 1866
9
Elma Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.8.4]
b. Dec 1871 d. Aft 22 Mar 1922
9
George Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.8.5]
b. Oct 1882 d. Aft 7 May 1910
Alice Webster
b. Abt 1887 d. Aft 7 May 1910
10
George H Whipple
[1.7.6.4.16.6.4.8.5.1]
+
Eugenia M M Carroll
+
Hannah Wilson
b. Abt 1817 d. 1867
+
Rosanna Trainer
b. 1817
7
Millie Whipple
[1.7.6.4.16.6.5]
b. 1818
Moses Handy
b. 1818
8
Nelson Handy
[1.7.6.4.16.6.5.1]
b. Abt 1841
9
William Handy
[1.7.6.4.16.6.5.1.1]
b. Abt 1861
8
Pardon Handy
[1.7.6.4.16.6.5.2]
b. Abt 1843
8
Whipple Handy
[1.7.6.4.16.6.5.3]
b. Abt 1845
8
William Handy
[1.7.6.4.16.6.5.4]
b. Abt 1847
+
Mary Ann Fox
b. Abt 1847
7
Abner J Whipple
[1.7.6.4.16.6.6]
b. 1822 d. 30 May 1893
Sarah Gibson
b. 22 Jan 1830 d. 27 Mar 1890
8
Jesse Whipple
[1.7.6.4.16.6.6.1]
b. 1849 d. 14 Sep 1894
+
Lora Barker
b. Abt 1849
8
Emma A Whipple
[1.7.6.4.16.6.6.2]
b. 5 Sep 1853 d. 17 Aug 1914
+
David Swales
b. Dec 1849
8
John Whipple
[1.7.6.4.16.6.6.3]
b. 1856
8
William Whipple
[1.7.6.4.16.6.6.4]
b. 1858
8
Thomas H Whipple
[1.7.6.4.16.6.6.5]
b. 1864 d. Dec 1913
6
Amey Whipple
[1.7.6.4.16.7]
b. 19 Sep 1773 d. 10 Nov 1851
Welcome Whipple
b. 12 Sep 1792 d. 10 Nov 1852
7
Milton Dexter Whipple
[1.7.6.4.16.7.1]
b. 3 Dec 1797 d. 10 Mar 1873
Lucy Perry
b. 1801
8
Lyman N Whipple
[1.7.6.4.16.7.1.1]
b. 1825
8
Lucy Ann Whipple
[1.7.6.4.16.7.1.2]
b. 1832
8
Randall M Whipple
[1.7.6.4.16.7.1.3]
b. 1837
7
Virgil Whipple
[1.7.6.4.16.7.2]
b. 20 May 1799 d. 13 Jan 1834
Almira Sprague
b. 4 May 1803 d. 11 Feb 1869
8
Eliza Ann Whipple
[1.7.6.4.16.7.2.1]
b. 22 Nov 1823 d. 17 Nov 1832
8
Amy Angeline Whipple
[1.7.6.4.16.7.2.2]
b. 1 Jun 1828 d. 7 Jan 1833
7
Cullen Whipple
[1.7.6.4.16.7.3]
b. 4 Sep 1801 d. 23 Oct 1858
Philanda Sprague
b. 30 Jun 1805 d. 1842
8
Angeline E Whipple
[1.7.6.4.16.7.3.1]
b. 13 Mar 1833 d. 3 Oct 1863
William Henry Shattuck
b. 1831 d. 21 Apr 1896
9
Philinda W Shattuck
[1.7.6.4.16.7.3.1.1]
b. Abt 1852 d. 23 May 1860
9
Enos L Shattuck
[1.7.6.4.16.7.3.1.2]
b. 29 Dec 1853 d. 24 Dec 1876
9
Almira L Shattuck
[1.7.6.4.16.7.3.1.3]
b. 3 Sep 1855 d. 27 May 1860
9
William S Shattuck
[1.7.6.4.16.7.3.1.4]
b. 22 Jun 1857 d. 20 May 1860
9
Mary Alice Shattuck
[1.7.6.4.16.7.3.1.5]
b. 16 Nov 1859
9
Lillian G Shattuck
[1.7.6.4.16.7.3.1.6]
b. 2 Feb 1863
Mary A Viall
b. 4 Apr 1823
8
George Cullen Whipple
[1.7.6.4.16.7.3.2]
b. 17 Sep 1843 d. 31 Oct 1875
Elizabeth Lindsay "Lizzie" McKay
b. 1852
9
Walter Alexander Whipple
[1.7.6.4.16.7.3.2.1]
b. 21 Mar 1875 d. 16 Jun 1967
Lena Mabel Young
b. 4 Aug 1875 d. 16 Nov 1944
10
Kenneth Young Whipple
[1.7.6.4.16.7.3.2.1.1]
b. 2 Jul 1902 d. 1974
10
Charles Cullen Whipple
[1.7.6.4.16.7.3.2.1.2]
b. 7 Aug 1906 d. 29 Oct 1994
+
Helen Howard Hudson
b. 26 Oct 1907 d. 26 Jun 1999
10
Grace Elizabeth Whipple
[1.7.6.4.16.7.3.2.1.3]
b. 11 Nov 1914 d. 7 Aug 2002
Howard Standing Congdon
b. 3 Jul 1912 d. 3 Aug 2001
11
Steven Whipple Congdon
[1.7.6.4.16.7.3.2.1.3.1]
11
Nancy Young Congdon
[1.7.6.4.16.7.3.2.1.3.2]
11
Jeffrey Davis Congdon
[1.7.6.4.16.7.3.2.1.3.3]
11
Alan Hamblin Congdon
[1.7.6.4.16.7.3.2.1.3.4]
b. 3 Nov 1949 d. 8 Mar 1987
8
Walter Trask Scott Whipple
[1.7.6.4.16.7.3.3]
b. 19 Jul 1846 d. 5 Mar 1874
8
Mary Luella Whipple
[1.7.6.4.16.7.3.4]
b. 21 Dec 1860 d. 4 Feb 1861
7
Justin Brown Whipple
[1.7.6.4.16.7.4]
b. 6 Jul 1803 d. 17 Aug 1881
Lucetta Packard
b. 1803
8
Charles A Whipple
[1.7.6.4.16.7.4.1]
b. 13 Jul 1832
Clarinda Ellen Belding
b. 8 May 1835 d. 26 Jan 1910
9
Adeline Edna Whipple
[1.7.6.4.16.7.4.1.1]
b. 18 Jun 1853 d. Aft Jan 1920
Walter Moses Adams
b. 23 May 1852
10
Edna May Adams
[1.7.6.4.16.7.4.1.1.1]
b. 1 Dec 1874
10
Ethel Lucetta Adams
[1.7.6.4.16.7.4.1.1.2]
b. 19 Nov 1876
10
Lewis Adams
[1.7.6.4.16.7.4.1.1.3]
b. 16 Feb 1881 d. Aft Jun 1900
10
Walter C Adams
[1.7.6.4.16.7.4.1.1.4]
b. Jul 1883 d. Aft Jan 1920
10
William Adams
[1.7.6.4.16.7.4.1.1.5]
b. 19 Aug 1887 d. Aft Apr 1910
9
Elwin F Whipple
[1.7.6.4.16.7.4.1.2]
b. 20 Feb 1857 d. Aft Jan 1920
9
Inez E Whipple
[1.7.6.4.16.7.4.1.3]
b. 9 Mar 1867 d. Aft Jan 1920
+
Arthur Dana Bowers
b. Abt 1857
7
Mary Ann Whipple
[1.7.6.4.16.7.5]
b. 29 Sep 1805 d. 9 Nov 1885
Jonathan Sprague
b. 6 Oct 1801 d. Nov 1876
8
Welcome Whipple Sprague
[1.7.6.4.16.7.5.1]
b. 9 Feb 1828 d. 26 Mar 1884
Mary Taft Rawson
b. 8 Feb 1830 d. 6 May 1893
9
Homer Baxter Sprague
[1.7.6.4.16.7.5.1.1]
b. 22 Aug 1859
Matilda Eliza Clinch
b. Aug 1864
10
Emma Mildred Sprague
[1.7.6.4.16.7.5.1.1.1]
b. Sep 1889
9
Frederick Augustus Sprague
[1.7.6.4.16.7.5.1.2]
b. 9 Dec 1853 d. 1920
Lucy Maria Johnson
b. 25 Dec 1867 d. 4 Dec 1948
10
Fredrick Homer Sprague
[1.7.6.4.16.7.5.1.2.1]
b. 24 Sep 1886
8
Homer Baxter Sprague
[1.7.6.4.16.7.5.2]
b. 19 Sep 1829 d. 23 Mar 1918
Antoinette Elizabeth Pardee
b. 29 Oct 1836 d. 30 Jan 1913
9
Charles Homer Sprague
[1.7.6.4.16.7.5.2.1]
b. 21 Jul 1856
+
Jennie L Starbuck
b. 10 Oct 1858
9
Sarah Antoinette Sprague
[1.7.6.4.16.7.5.2.2]
b. 24 Dec 1858
William W Davis
b. 7 Oct 1858
10
Daughter Davis
[1.7.6.4.16.7.5.2.2.1]
b. 30 Jan 1882
9
William Pardee Sprague
[1.7.6.4.16.7.5.2.3]
b. 24 Jun 1860
+
Louise Velbert
b. 24 Feb 1856
9
Goldwin Smith Sprague
[1.7.6.4.16.7.5.2.4]
b. 17 Oct 1869
+
Isabel Dewey Bailey
b. 3 Feb 1875
8
Frances Maria Sprague
[1.7.6.4.16.7.5.3]
b. 13 Sep 1831 d. 14 Jul 1893
Mason W Morse
b. 2 Mar 1823 d. 7 Feb 1892
9
Scott Morse
[1.7.6.4.16.7.5.3.1]
b. 16 Nov 1853
Hattie A Taylor
10
Hattie Maria Morse
[1.7.6.4.16.7.5.3.1.1]
b. 28 Jan 1873
Leon Erving Thayer
b. 11 Sep 1872 d. 20 Nov 1964
11
Irving Adelbert Thayer
[1.7.6.4.16.7.5.3.1.1.1]
b. 30 Aug 1894 d. 1911
11
Warren Ellsworth Thayer
[1.7.6.4.16.7.5.3.1.1.2]
b. 10 Jan 1897 d. 1960
9
Charles Augustus Morse
[1.7.6.4.16.7.5.3.2]
b. 7 Apr 1859
9
Frank Sprague Morse
[1.7.6.4.16.7.5.3.3]
b. 12 Sep 1861
8
Charles Augustus Sprague
[1.7.6.4.16.7.5.4]
b. 24 Feb 1834 d. 1909
Sarah Maria Pattison
b. 22 Sep 1837 d. 6 Sep 1887
9
Carrie Smith Sprague
[1.7.6.4.16.7.5.4.1]
b. 23 Mar 1863 d. 27 Aug 1884
9
Alice May Sprague
[1.7.6.4.16.7.5.4.2]
b. 16 Apr 1871 d. 23 May 1891
+
Flora Amanda Smith
b. 4 Mar 1862 d. 1915
8
Solon Smith Sprague
[1.7.6.4.16.7.5.5]
b. 5 Mar 1836 d. 3 Jun 1881
Caroline H Stevens
b. 15 Oct 1835 d. 21 Feb 1910
9
Walter Irving Sprague
[1.7.6.4.16.7.5.5.1]
b. 12 Oct 1855
+
Ella Gustina Coates
b. 9 May 1857
9
Adaline Estelle Sprague
[1.7.6.4.16.7.5.5.2]
b. 15 Jul 1858 d. 16 Jul 1906
+
Fred Foster Sprague
b. 24 Oct 1864 d. 16 Jul 1906
9
Elliott Almarand Sprague
[1.7.6.4.16.7.5.5.3]
b. 26 Dec 1868
8
Mary Ann Sprague
[1.7.6.4.16.7.5.6]
b. 8 Feb 1838 d. 20 Sep 1864
+
Daniel Putnam Day
b. 14 Nov 1832 d. 29 Nov 1909
8
Jonathan Almaran Sprague
[1.7.6.4.16.7.5.7]
b. 20 May 1844 d. 18 Sep 1864
8
Flora Emma Sprague
[1.7.6.4.16.7.5.8]
b. 5 Feb 1847
+
Byron Orlando Prentice
b. 9 Oct 1846 d. 3 Dec 1869
+
Harding Allen
b. 2 Apr 1838 d. 18 Apr 1899
8
Philinda W Sprague
[1.7.6.4.16.7.5.9]
b. 24 Feb 1849 d. 28 Feb 1850
7
Homer Baxter Whipple
[1.7.6.4.16.7.6]
b. 12 Jun 1808 d. 7 Mar 1866
Prudence Emerson
b. 1809
8
Ida J Whipple
[1.7.6.4.16.7.6.1]
b. 1848
William Zane Selby
b. Abt 1839 d. Aft 1900
9
Homer J Selby
[1.7.6.4.16.7.6.1.1]
b. Abt 1869 d. 18 Aug 1945
Lilly J Nelson
b. 1879
10
George William Selby
[1.7.6.4.16.7.6.1.1.1]
b. 1907
+
Grace Marie Ballinger
b. 30 May 1910
9
Carrie Belle Selby
[1.7.6.4.16.7.6.1.2]
b. Abt 1871 d. Aft 1930
9
Effie Selby
[1.7.6.4.16.7.6.1.3]
b. Abt 1877
7
Dryden E Whipple
[1.7.6.4.16.7.7]
b. 4 Mar 1811
7
Ardalissa Whipple
[1.7.6.4.16.7.8]
b. 17 Sep 1813
+
Benson Norbury
b. 14 May 1833 d. 2 Apr 1919
6
Freelove Whipple
[1.7.6.4.16.8]
b. 5 Dec 1775 d. 27 Jan 1853
James Waterman
b. 9 Apr 1777 d. 21 Feb 1812
7
Louisa Waterman
[1.7.6.4.16.8.1]
b. 1797
+
Mowry Taft
7
Sarah Waterman
[1.7.6.4.16.8.2]
b. 1799
Ambrose Clarke
b. 26 Jul 1796
8
Rizpah Jenckes Clarke
[1.7.6.4.16.8.2.1]
b. 1820 d. 15 Jun 1910
7
Amaziah Waterman
[1.7.6.4.16.8.3]
b. 14 Nov 1801 d. 8 Mar 1837
Hannah Lee
b. 26 Jan 1804 d. 14 Feb 1837
8
Alpha Lee Waterman
[1.7.6.4.16.8.3.1]
b. 11 Sep 1825 d. 3 Nov 1878
Nehemiah Nelson Carpenter
b. 1819 d. 12 Jul 1865
9
Halsey Walcot Carpenter
[1.7.6.4.16.8.3.1.1]
b. 1845
9
Mary Taft Carpenter
[1.7.6.4.16.8.3.1.2]
b. 1847
9
Henry Waterman Carpenter
[1.7.6.4.16.8.3.1.3]
b. 1849
9
Elmer Nehemiah Carpenter
[1.7.6.4.16.8.3.1.4]
b. 1851
9
Mowry T Carpenter
[1.7.6.4.16.8.3.1.5]
b. 1853 d. 28 Jun 1913
8
Elisha Waterman
[1.7.6.4.16.8.3.2]
b. 4 Jan 1828
8
Rufus Waterman
[1.7.6.4.16.8.3.3]
b. 10 Feb 1831 d. 19 Apr 1885
Adeline Dexter Carpenter
b. 11 Mar 1838
9
Richard Waterman
[1.7.6.4.16.8.3.3.1]
b. 15 Oct 1857
8
Richard Waterman
[1.7.6.4.16.8.3.4]
b. 13 Mar 1834 d. 11 Mar 1925
Rebecca Sheldon Carpenter
b. 6 Jun 1840 d. 17 Jul 1921
9
Elisha Amaziah Waterman
[1.7.6.4.16.8.3.4.1]
b. 16 Jul 1858 d. 2 Feb 1931
+
Susan Homer Evans
b. Abt 1859 d. 1 Jan 1938
9
Elsie Carpenter Waterman
[1.7.6.4.16.8.3.4.2]
b. 18 Jan 1866 d. 15 May 1913
9
Byron Levi Waterman
[1.7.6.4.16.8.3.4.3]
b. 14 Mar 1870 d. 1964
Lucy Frances Clark
b. 21 Apr 1878 d. 5 Apr 1939
10
Helen Waterman
[1.7.6.4.16.8.3.4.3.1]
b. 9 May 1898 d. 1976
Irving Edward Knight
b. 31 Aug 1897 d. 1953
11
Irving Waterman Knight
[1.7.6.4.16.8.3.4.3.1.1]
b. 21 Sep 1923 d. 7 Oct 2010
11
Robert Francis Knight
[1.7.6.4.16.8.3.4.3.1.2]
b. 19 Oct 1924 d. 15 Apr 1943
11
Marjorie Knight
[1.7.6.4.16.8.3.4.3.1.3]
b. 1 Apr 1934 d. 17 Oct 2011
+
William Thomas Sweetman
b. 10 Mar 1934 d. 19 Sep 2011
11
Living
[1.7.6.4.16.8.3.4.3.1.4]
+
Living
6
Silence Whipple
[1.7.6.4.16.9]
b. 23 Oct 1781 d. 23 Jan 1864
Joshua Arnold
b. 20 Aug 1784 d. 14 Oct 1852
7
Elizabeth Arnold
[1.7.6.4.16.9.1]
b. 1 Jan 1808 d. 11 Feb 1898
Arthur Whipple
b. 30 Nov 1793 d. 17 Dec 1853
8
Amanda Whipple
[1.7.6.4.16.9.1.1]
b. 17 Nov 1829 d. 17 Dec 1832
8
John Whipple
[1.7.6.4.16.9.1.2]
b. Abt 1834 d. 26 Oct 1834
8
Amey Ann Whipple
[1.7.6.4.16.9.1.3]
b. Sep 1836 d. Aft Apr 1910
Benjamin Phetteplace
b. 1848
9
Annie E Phetteplace
[1.7.6.4.16.9.1.3.1]
b. Abt 1859
9
Laura M Phetteplace
[1.7.6.4.16.9.1.3.2]
b. 1861 d. 16 May 1937
+
Daniel Loynds
b. 28 Mar 1861
9
Sarah Whipple Phetteplace
[1.7.6.4.16.9.1.3.3]
b. Abt 1864 d. 19 Nov 1919
Winfield Dextor Smith
b. Abt 1861 d. 3 Nov 1939
10
Frank Stearns Smith
[1.7.6.4.16.9.1.3.3.1]
b. 24 Sep 1888 d. 25 May 1945
+
Gertrude Hamilton
10
Alison Parkhurst Smith
[1.7.6.4.16.9.1.3.3.2]
b. Abt 1890 d. 19 Jan 1937
9
Benjamin Lester Phetteplace
[1.7.6.4.16.9.1.3.4]
b. Apr 1866 d. 8 Nov 1938
Susan Squires
10
Benjamin Squire Phetteplace
[1.7.6.4.16.9.1.3.4.1]
b. 24 Nov 1894 d. Aft 1930
Elizabeth
b. Abt 1892 d. Aft 1930
11
Elizabeth T Phetteplace
[1.7.6.4.16.9.1.3.4.1.1]
11
Patricia Ann Phetteplace
[1.7.6.4.16.9.1.3.4.1.2]
10
Wesley Merritt Phetteplace
[1.7.6.4.16.9.1.3.4.2]
b. 11 Jun 1898 d. 10 Feb 1977
+
Hazel M Estey
b. 26 Sep 1893 d. 17 Aug 1975
8
Jeremiah Whipple
[1.7.6.4.16.9.1.4]
b. 1840 d. 18 Jul 1866
+
Eliza Minerva Whipple
b. 25 Dec 1831 d. 21 Jan 1926
8
Phebe Whipple
[1.7.6.4.16.9.1.5]
b. 18 Aug 1841 d. 6 Apr 1930
John Kay Dexter
b. Abt 1838 d. 22 Apr 1915
9
John Dexter
[1.7.6.4.16.9.1.5.1]
b. 11 Jun 1863 d. 24 Oct 1927
Grace Eveline Huling
b. 17 Aug 1858 d. 31 Dec 1941
10
Carrol Huling Dexter
[1.7.6.4.16.9.1.5.1.1]
b. 8 Oct 1893 d. 6 Oct 1948
9
Frederick Everett Dexter
[1.7.6.4.16.9.1.5.2]
b. 21 Jun 1869 d. 11 Dec 1949
James Newell Phetteplace
b. Jul 1837 d. 1 Aug 1908
9
Morton Phetteplace
[1.7.6.4.16.9.1.5.3]
b. 25 Dec 1879 d. Aft 1942
Mary Evelyn Harris
b. 1 Nov 1880 d. 15 Jul 1933
10
George Morton Phetteplace
[1.7.6.4.16.9.1.5.3.1]
b. Abt 1905 d. 16 Jan 1912
10
Helen A Phetteplace
[1.7.6.4.16.9.1.5.3.2]
b. 13 Aug 1907 d. Jan 1994
10
James Burton Phetteplace
[1.7.6.4.16.9.1.5.3.3]
b. 20 Sep 1909 d. Feb 1985
10
Alice E Phetteplace
[1.7.6.4.16.9.1.5.3.4]
b. 1 Sep 1910 d. 24 Sep 1990
9
Sarah Evelyn Phetteplace
[1.7.6.4.16.9.1.5.4]
b. 17 Jun 1882
8
Laura Jane Whipple
[1.7.6.4.16.9.1.6]
b. 1844 d. 21 Dec 1936
Thomas Leferga Jollie
b. 1843 d. 8 Dec 1911
9
Laura Etta Jollie
[1.7.6.4.16.9.1.6.1]
b. 17 Jun 1877
9
Mary E "Mame" Jollie
[1.7.6.4.16.9.1.6.2]
9
Nellie Augusta "Nell" Jollie
[1.7.6.4.16.9.1.6.3]
b. Abt 1868
Walter Bert Gardiner
b. Abt 1868
10
Milton Warren Gardner
[1.7.6.4.16.9.1.6.3.1]
b. 3 Nov 1897 d. 22 May 1988
+
Florence Etta Anderton
b. 6 Jun 1897 d. 3 May 1984
9
Isabel Dora Jollie
[1.7.6.4.16.9.1.6.4]
b. 21 Sep 1872 d. 14 Apr 1972
9
Fred L Jollie
[1.7.6.4.16.9.1.6.5]
9
Ettie E Jollie
[1.7.6.4.16.9.1.6.6]
9
Eva May Jollie
[1.7.6.4.16.9.1.6.7]
b. 14 Apr 1880
8
Eliza Emma Whipple
[1.7.6.4.16.9.1.7]
b. 26 Feb 1846 d. 21 Nov 1901
Charles Joseph Northup
b. 16 Mar 1846 d. 22 Oct 1917
9
Daniel Anthony Northup
[1.7.6.4.16.9.1.7.1]
b. 17 Jan 1867 d. 4 Jan 1935
Annis Brown
b. 19 Aug 1870 d. 1951
10
Charlotte Northup
[1.7.6.4.16.9.1.7.1.1]
b. 28 Jul 1877 d. 18 Aug 1878
10
Charles Henry Northup
[1.7.6.4.16.9.1.7.1.2]
b. 16 Sep 1894 d. 20 Feb 1963
Bertha Oldfield
b. 28 Jan 1892 d. 21 Mar 1936
11
Dorcas Annis Northup
[1.7.6.4.16.9.1.7.1.2.1]
b. 17 Nov 1922 d. 8 Feb 1986
11
Charles Henry Northup
[1.7.6.4.16.9.1.7.1.2.2]
b. 11 Feb 1924 d. 13 Dec 1997
10
Living
[1.7.6.4.16.9.1.7.1.3]
9
Eunice Mabell Northup
[1.7.6.4.16.9.1.7.2]
b. 24 Oct 1874 d. 15 Jul 1875
9
Elizabeth Ellen Northup
[1.7.6.4.16.9.1.7.3]
b. 11 Dec 1880 d. 22 Jan 1956
Edgar Franklin Curtis
b. 4 Feb 1878 d. 6 Nov 1947
10
Earl Myron Curtis
[1.7.6.4.16.9.1.7.3.1]
10
Walter Benjamin Curtis
[1.7.6.4.16.9.1.7.3.2]
10
Esther Lillian Curtis
[1.7.6.4.16.9.1.7.3.3]
9
Carrie Emma Northup
[1.7.6.4.16.9.1.7.4]
b. Jul 1883 d. 8 Oct 1966
Frank Waldo Curtis
b. 28 Jun 1885 d. 8 Jul 1967
10
Alfred Milton Curtis
[1.7.6.4.16.9.1.7.4.1]
b. 13 Jul 1909 d. 3 Jul 1942
10
Raymond Elton Curtis
[1.7.6.4.16.9.1.7.4.2]
b. 6 Mar 1912 d. 20 Sep 1920
7
Horace Arnold
[1.7.6.4.16.9.2]
b. Abt 1810 d. 7 Aug 1876
7
Diana Arnold
[1.7.6.4.16.9.3]
b. 1811 d. 8 Jun 1884
7
Mary Arnold
[1.7.6.4.16.9.4]
b. Abt 1812
7
Sylva Arnold
[1.7.6.4.16.9.5]
b. 1813 d. 12 Apr 1866
George Olney Smith
b. 17 Feb 1789 d. 19 Mar 1870
8
George Ellis Smith
[1.7.6.4.16.9.5.1]
b. 1854 d. 1917
Katherine Wermes
b. 1862 d. 1903
9
Lillian May Smith
[1.7.6.4.16.9.5.1.1]
b. 1886 d. 1950
9
George Onie Smith
[1.7.6.4.16.9.5.1.2]
b. 1888 d. 1960
9
Ellis M Smith
[1.7.6.4.16.9.5.1.3]
b. 1890 d. 1904
9
Annie Hampton Smith
[1.7.6.4.16.9.5.1.4]
b. 1891 d. 1905
9
Lewis Smith
[1.7.6.4.16.9.5.1.5]
b. 1893
9
Leonard Smith
[1.7.6.4.16.9.5.1.6]
b. 4 Nov 1895 d. 2 Nov 1970
Angeline Mabel Rank
b. 14 Jan 1909 d. 17 Feb 1979
10
Ronald George Smith
[1.7.6.4.16.9.5.1.6.1]
b. 2 May 1941 d. 7 Feb 2009
9
Paul William Smith
[1.7.6.4.16.9.5.1.7]
b. 1898
9
Peter Joseph Smith
[1.7.6.4.16.9.5.1.8]
b. 12 Jun 1900 d. 15 Feb 1976
Alice Julia Ferris
b. 22 Aug 1902 d. 7 Jun 1992
10
Mary Elizabeth Smith
[1.7.6.4.16.9.5.1.8.1]
b. 18 Sep 1933 d. 18 Feb 1996
8
Hattie J Smith
[1.7.6.4.16.9.5.2]
+
James Hampson
b. 1842 d. 19 Sep 1878
7
Miranda Arnold
[1.7.6.4.16.9.6]
b. Abt 1815 d. 17 Jun 1901
William Whipple Spaulding
b. 1 May 1810
8
Charles Frederick Spaulding
[1.7.6.4.16.9.6.1]
b. Abt Aug 1838 d. 27 Jan 1923
Charlotte Anne Jenckes
b. Sep 1835 d. 2 Apr 1921
9
Lottie May Spaulding
[1.7.6.4.16.9.6.1.1]
b. Abt 1871 d. 22 Nov 1883
8
Joseph Eleazer Spaulding
[1.7.6.4.16.9.6.2]
b. Abt 1838 d. 3 Feb 1915
Harriet Melissa Arnold
b. Abt 1844 d. 8 Oct 1914
9
Frank Edward Spaulding
[1.7.6.4.16.9.6.2.1]
b. Abt 1870 d. 21 Aug 1938
+
Sarah Ann Shaw
b. Abt 1887
9
Etta Belle Spaulding
[1.7.6.4.16.9.6.2.2]
b. 16 Dec 1890 d. Aft Apr 1910
8
George Henry Spaulding
[1.7.6.4.16.9.6.3]
b. Abt 1841 d. 9 Feb 1938
+
Abbie Williams Thayer
b. 1850 d. 1925
8
John Adams Spaulding
[1.7.6.4.16.9.6.4]
b. Abt 1843 d. 5 Dec 1916
Sarra Hopkins
9
John Hopkins Spaulding
[1.7.6.4.16.9.6.4.1]
b. 6 Sep 1869
8
Nathaniel Arnold Spaulding
[1.7.6.4.16.9.6.5]
b. 22 Feb 1847 d. 1937
Cora Belle Aldrich
b. Apr 1858 d. 1918
9
Alice Follett Spaulding
[1.7.6.4.16.9.6.5.1]
b. Dec 1880 d. 1969
Henry Moore
b. 23 Nov 1884 d. 16 Jan 1944
10
Henry E Moore
[1.7.6.4.16.9.6.5.1.1]
10
Marion Moore
[1.7.6.4.16.9.6.5.1.2]
9
Nathaniel Warren Spaulding
[1.7.6.4.16.9.6.5.2]
b. 11 Apr 1884 d. Aft 1942
Agnes Martha Vinton
b. Abt 1887 d. Aft 1942
10
Elsie V Spaulding
[1.7.6.4.16.9.6.5.2.1]
10
Nathaniel R Spaulding
[1.7.6.4.16.9.6.5.2.2]
8
Joshua Edwards Spaulding
[1.7.6.4.16.9.6.6]
b. May 1849 d. 11 Apr 1939
Ruhamah Caroline Wilson
b. May 1849 d. 19 Mar 1919
9
Arbella Wilson Spaulding
[1.7.6.4.16.9.6.6.1]
b. 4 Jan 1876
9
Everett Garfield Spaulding
[1.7.6.4.16.9.6.6.2]
b. 24 Apr 1880 d. 24 Aug 1945
+
Mae Estelle Meservey
b. Abt 1888
9
George Ernest Spaulding
[1.7.6.4.16.9.6.6.3]
b. 25 Jun 1884 d. Aft Apr 1930
8
William Whipple Spaulding, Jr
[1.7.6.4.16.9.6.7]
b. Abt 1852 d. 29 Nov 1893
+
Martha Ann Jollie
b. 22 Dec 1851 d. 7 Aug 1906
7
Adam Arnold
[1.7.6.4.16.9.7]
b. 4 Feb 1819 d. 4 Jun 1895
Eliza Ann Vose
b. 4 Apr 1811 d. 17 Oct 1861
8
Adelaide Arnold
[1.7.6.4.16.9.7.1]
b. 1849 d. 1900
+
Melissa Lucinda Congdon
7
Hannah Arnold
[1.7.6.4.16.9.8]
b. Abt 1822 d. 28 Sep 1905
Henry Short
8
John S Short
[1.7.6.4.16.9.8.1]
b. Abt 1856 d. 17 Feb 1920
8
Joshua Short
[1.7.6.4.16.9.8.2]
b. 1858 d. 4 Feb 1858
8
Jeremiah Short
[1.7.6.4.16.9.8.3]
b. 1859 d. 28 Jun 1859
5
Hannah Whipple
[1.7.6.4.17]
b. 2 May 1735 d. 22 Nov 1825
Christopher Jenckes
b. 1725 d. 22 Nov 1825
6
Lydia Jenckes
[1.7.6.4.17.1]
b. 8 Dec 1752
John Mathewson
b. 7 Jun 1746 d. 1835
7
Peregrin Mathewson
[1.7.6.4.17.1.1]
b. 17 Jan 1775
Susan Webb
b. 1780
8
Elisha Mathewson
[1.7.6.4.17.1.1.1]
b. 25 Nov 1820 d. 1895
7
Welcome Mathewson
[1.7.6.4.17.1.2]
b. 15 Aug 1778 d. 1872
Abigail Brown
b. Abt 1786 d. 1872
8
Mary Ann Mathewson
[1.7.6.4.17.1.2.1]
b. 8 May 1808 d. 15 Oct 1886
Henry Sweet
b. 18 Jul 1812 d. Mar 1879
9
Abbie F Sweet
[1.7.6.4.17.1.2.1.1]
b. 2 Sep 1834 d. 1917
9
Thomas Henry Sweet
[1.7.6.4.17.1.2.1.2]
b. 13 Apr 1838 d. 1924
+
Lydia S Olney
b. 1834 d. 1919
9
Albert E Sweet
[1.7.6.4.17.1.2.1.3]
b. 18 Sep 1841
9
Mary Ellen
[1.7.6.4.17.1.2.1.4]
b. 21 Mar 1845
9
Emor W Sweet
[1.7.6.4.17.1.2.1.5]
b. 29 Jun 1848 d. 12 Jul 1850
9
Elnor W Sweet
[1.7.6.4.17.1.2.1.6]
b. 29 Jun 1848 d. 12 Jul 1850
8
David Mathewson
[1.7.6.4.17.1.2.2]
b. 29 Dec 1817 d. 14 May 1896
+
Emeline Maria Wood
b. 23 Sep 1821
7
Hannah Mathewson
[1.7.6.4.17.1.3]
b. 18 Apr 1781
7
John Mathewson
[1.7.6.4.17.1.4]
b. 1 Jan 1785
7
Lydia Mathewson
[1.7.6.4.17.1.5]
b. 18 Apr 1787
7
Anphillis Mathewson
[1.7.6.4.17.1.6]
b. 4 Mar 1790
7
Amey Mathewson
[1.7.6.4.17.1.7]
b. 3 Feb 1795
6
Joshua Jenckes
[1.7.6.4.17.2]
b. 15 Jan 1754 d. Jun 1807
Susannah Whipple
b. 11 Jul 1762 d. 1 Feb 1832
7
Salinda Jenckes
[1.7.6.4.17.2.1]
b. 21 Feb 1799 d. 2 Feb 1856
+
William Howard
b. Abt 1797
7
Anphillas Jenckes
[1.7.6.4.17.2.2]
b. 25 Sep 1800
7
Parley Jenckes
[1.7.6.4.17.2.3]
b. 31 Jan 1802 d. 28 Mar 1866
+
Newel Phetteplace
b. Abt 1804
7
Hannah Jenckes
[1.7.6.4.17.2.4]
b. 1 Jul 1803 d. 1852
7
Lemuel Jenckes
[1.7.6.4.17.2.5]
b. Abt 1805 d. 10 Jul 1845
6
Hannah Jenckes
[1.7.6.4.17.3]
b. 21 Jul 1756
6
Anphillis Jenckes
[1.7.6.4.17.4]
b. 20 Feb 1757
6
Christopher Jenckes
[1.7.6.4.17.5]
b. 17 May 1760
6
Adam Jenckes
[1.7.6.4.17.6]
b. 7 Nov 1762 d. Aft 1835
6
Elizabeth Jenckes
[1.7.6.4.17.7]
b. 11 Feb 1764
6
Amie Jenckes
[1.7.6.4.17.8]
b. 21 Sep 1770
6
General Charles Jenckes
[1.7.6.4.17.9]
b. 7 Aug 1767 d. 4 Jul 1838
Rachel Benson
b. 5 May 1777 d. 21 Nov 1842
7
Charles Benson Jenckes
[1.7.6.4.17.9.1]
b. 10 Apr 1796 d. Aft 1831
Hannah Ellis Thayer
b. 19 Mar 1800 d. 26 Feb 1818
8
Charles T Jenckes
[1.7.6.4.17.9.1.1]
b. 20 Feb 1818 d. 28 Feb 1818
Urana Thayer
b. 26 Dec 1801 d. 15 Nov 1822
8
Rufus A Jenckes
[1.7.6.4.17.9.1.2]
b. 22 Sep 1822 d. 11 Oct 1822
+
Alice T Thayer
b. Abt 1802 d. 28 Mar 1826
Ann Eliza Smith
b. 31 Dec 1805 d. 2 Apr 1865
8
Hannah Eliza Jenckes
[1.7.6.4.17.9.1.3]
b. 25 Nov 1827 d. 22 Oct 1890
+
Edwin Smith
b. Abt 1825
8
Charles Henry Jenckes
[1.7.6.4.17.9.1.4]
b. 17 Nov 1829 d. 1862
Susan Jenks
b. Abt 1831 d. 1919
9
Anna Maria Jencks
[1.7.6.4.17.9.1.4.1]
b. 31 Dec 1851 d. 31 Jul 1910
9
Henry Benson Jencks
[1.7.6.4.17.9.1.4.2]
b. 12 Jan 1861 d. 20 Jan 1925
Eva Elmira Stone
b. 4 Apr 1859 d. 20 Dec 1949
10
Esther Emeline Jencks
[1.7.6.4.17.9.1.4.2.1]
b. 14 Oct 1890 d. 25 Feb 1977
10
Ralph Joseph Jencks
[1.7.6.4.17.9.1.4.2.2]
b. 4 Apr 1892 d. 12 Jan 1931
8
Ann Mariah Jenckes
[1.7.6.4.17.9.1.5]
b. 31 Dec 1831 d. 31 Jul 1910
Dr James Lucas Wheaton
b. 14 Mar 1823
9
Martha Jenckes Wheaton
[1.7.6.4.17.9.1.5.1]
b. 12 Feb 1851
+
Dr. William P White
b. 21 Dec 1845 d. 31 Dec 1871
Julian A Chase
10
Elizabeth Kimball Chase
[1.7.6.4.17.9.1.5.1.1]
b. 3 Feb 1875
10
Anna Margaret Chase
[1.7.6.4.17.9.1.5.1.2]
b. 14 May 1876 d. 11 Jan 1955
+
Charles Herbert Sheldon
b. 1872
10
Julian Clement Chase
[1.7.6.4.17.9.1.5.1.3]
b. 21 Jun 1878 d. 14 Feb 1974
Julia Ramsey
11
Robert Ramsey Chase
[1.7.6.4.17.9.1.5.1.3.1]
b. 1911 d. 1998
+
Olga Schwind
b. 1917 d. 14 Dec 2004
+
Beulah Dimmick
b. 1901 d. 1990
10
Ruth Chase
[1.7.6.4.17.9.1.5.1.4]
b. 30 Aug 1880
10
Helen Burr Chase
[1.7.6.4.17.9.1.5.1.5]
b. 3 Jan 1885
10
Hazel White Chase
[1.7.6.4.17.9.1.5.1.6]
b. 3 Jan 1885 d. 18 Apr 1888
10
Robert Dexter Chase
[1.7.6.4.17.9.1.5.1.7]
b. 8 Jan 1889
Elizabeth Wadsworth Dodge
b. 27 Feb 1888
11
Robert Dexter Chase, Jr
[1.7.6.4.17.9.1.5.1.7.1]
b. 18 Jul 1917 d. 1 Jun 1985
9
Anna Francis Wheaton
[1.7.6.4.17.9.1.5.2]
b. 27 Feb 1853
Samuel Francis Dexter
b. 3 Sep 1872
10
Nathaniel Wheaton Dexter
[1.7.6.4.17.9.1.5.2.1]
b. 9 Jan 1874 d. 12 Oct 1959
10
Fannie Wheaton Dexter
[1.7.6.4.17.9.1.5.2.2]
b. 21 Oct 1875 d. 19 Jul 1948
10
Anthony Hamilton Dexter
[1.7.6.4.17.9.1.5.2.3]
b. 1 May 1881
+
Helen Loesch
b. Abt 1879
9
Jesse L Wheaton
[1.7.6.4.17.9.1.5.3]
b. Dec 1860
9
James Lucas Wheaton, Jr
[1.7.6.4.17.9.1.5.4]
b. 9 Jul 1868
Florence Evelyn Jefferds
b. 15 Jun 1876
10
Dr James Lucas Wheaton, III
[1.7.6.4.17.9.1.5.4.1]
b. 4 Oct 1899 d. 28 May 1979
Doris May Sibley
b. 12 Jan 1899 d. 26 Sep 1970
11
Betty Wheaton
[1.7.6.4.17.9.1.5.4.1.1]
b. 16 May 1925 d. 21 Mar 1992
Paul Oscar Avery
b. 20 Apr 1921 d. 5 Mar 2003
12
Christopher Wheaton Avery
[1.7.6.4.17.9.1.5.4.1.1.1]
b. 7 Aug 1948 d. 10 Feb 2001
11
James Lucas Wheaton, IV
[1.7.6.4.17.9.1.5.4.1.2]
b. 6 Apr 1930 d. 7 Oct 2004
10
Dorothy Evelyn Wheaton
[1.7.6.4.17.9.1.5.4.2]
b. 11 May 1903
4
Sarah Sprague
[1.7.6.5]
b. 7 Mar 1696 d. 12 Aug 1741
4
Lydia Sprague
[1.7.6.6]
b. 27 Sep 1699 d. 5 Jun 1736
4
Hannah Sprague
[1.7.6.7]
b. 12 Mar 1700 d. 28 Nov 1704
4
Mercy Sprague
[1.7.6.8]
b. 17 Jun 1703 d. 19 Apr 1749
Daniel Jenckes
b. 12 Mar 1702 d. 24 Jan 1789
5
Catherine Jenckes
[1.7.6.8.1]
b. 23 Mar 1729
5
Jeremiah Jenckes
[1.7.6.8.2]
b. 12 Feb 1730 d. 17 Feb 1819
5
Hannah Jenckes
[1.7.6.8.3]
b. 1 Nov 1732 d. 25 Nov 1794
5
John Jenckes
[1.7.6.8.4]
b. 2 Nov 1734 d. 22 Feb 1818
5
Phebe Jencks
[1.7.6.8.5]
b. 14 Feb 1735 d. 1828
5
Mercy Jenckes
[1.7.6.8.6]
b. 2 Sep 1737 d. 18 Feb 1797
5
Mary Jenckes
[1.7.6.8.7]
b. 2 Sep 1737
5
David Jenckes
[1.7.6.8.8]
b. 21 Jun 1739 d. 3 Dec 1822
5
Daniel Jenckes
[1.7.6.8.9]
b. 19 Mar 1743 d. 1801
Sarah Whipple
b. 26 Dec 1741 d. Aft May 1784
6
Gideon Jenckes
[1.7.6.8.9.1]
b. 31 May 1764 d. 25 Sep 1822
Anna White
b. 9 Apr 1769 d. 15 Oct 1850
7
Daniel Jenckes
[1.7.6.8.9.1.1]
b. 24 Aug 1788 d. 1846
Sophia Cargill
b. 1793 d. 3 Feb 1862
8
Susan Jenckes
[1.7.6.8.9.1.1.1]
b. 1812 d. 17 Oct 1837
8
Carolina A Jenckes
[1.7.6.8.9.1.1.2]
b. 1815 d. 4 Jun 1837
8
Leprellet Jenckes
[1.7.6.8.9.1.1.3]
b. 1816 d. 16 Jan 1894
8
Sarah W Jenckes
[1.7.6.8.9.1.1.4]
b. 1819 d. 24 Dec 1876
8
Daniel A Jenckes
[1.7.6.8.9.1.1.5]
b. 1824 d. 10 Jul 1886
8
Louisa Jenckes
[1.7.6.8.9.1.1.6]
b. Abt 1826 d. 1 Sep 1880
8
Sophronia Jenckes
[1.7.6.8.9.1.1.7]
b. Abt 1828
8
Mary C Jenckes
[1.7.6.8.9.1.1.8]
b. 1831 d. 5 Sep 1836
8
Charlotte Anne Jenckes
[1.7.6.8.9.1.1.9]
b. Sep 1835 d. 2 Apr 1921
Charles Frederick Spaulding
b. Abt Aug 1838 d. 27 Jan 1923
9
Lottie May Spaulding
[1.7.6.8.9.1.1.9.1]
b. Abt 1871 d. 22 Nov 1883
7
Isaac Jenckes
[1.7.6.8.9.1.2]
b. 13 Dec 1790 d. 3 Apr 1851
7
William Jenckes
[1.7.6.8.9.1.3]
b. 2 Jan 1796
7
Whipple Jenckes
[1.7.6.8.9.1.4]
b. 2 Nov 1798
7
Susanna Jenckes
[1.7.6.8.9.1.5]
b. 2 Jun 1803
7
Rhoda Jenckes
[1.7.6.8.9.1.6]
b. 21 Mar 1808
Rhoda Cruff
b. 9 Feb 1749
6
Lemuel Jenckes
[1.7.6.8.9.2]
b. 8 Aug 1768
6
Sarah Jenckes
[1.7.6.8.9.3]
b. 8 Sep 1769
6
Jabez Jenckes
[1.7.6.8.9.4]
b. 27 May 1784 d. 1805
6
Captain Sterry Jenckes
[1.7.6.8.9.5]
b. 6 Feb 1787 d. 26 Nov 1853
Anne Nancy Dexter
b. 1782
7
Horatio Nelson Jenckes
[1.7.6.8.9.5.1]
b. 8 Aug 1810 d. 30 Dec 1828
7
Elcy Ann Jenckes
[1.7.6.8.9.5.2]
b. 3 Sep 1813 d. 12 Dec 1828
7
Jabez Walcott Jenckes
[1.7.6.8.9.5.3]
b. 7 Jan 1815 d. 11 Jan 1883
7
Rhoda Ann Jenckes
[1.7.6.8.9.5.4]
b. 15 Jan 1818 d. 7 Aug 1847
Levi Carpenter
b. 28 Oct 1803 d. 22 May 1876
8
George Nelson Carpenter
[1.7.6.8.9.5.4.1]
b. 12 Oct 1836 d. 8 Apr 1839
8
Adeline Dexter Carpenter
[1.7.6.8.9.5.4.2]
b. 11 Mar 1838
Rufus Waterman
b. 10 Feb 1831 d. 19 Apr 1885
9
Richard Waterman
[1.7.6.8.9.5.4.2.1]
b. 15 Oct 1857
8
Rebecca Sheldon Carpenter
[1.7.6.8.9.5.4.3]
b. 6 Jun 1840 d. 17 Jul 1921
Richard Waterman
b. 13 Mar 1834 d. 11 Mar 1925
9
Elisha Amaziah Waterman
[1.7.6.8.9.5.4.3.1]
b. 16 Jul 1858 d. 2 Feb 1931
+
Susan Homer Evans
b. Abt 1859 d. 1 Jan 1938
9
Elsie Carpenter Waterman
[1.7.6.8.9.5.4.3.2]
b. 18 Jan 1866 d. 15 May 1913
9
Byron Levi Waterman
[1.7.6.8.9.5.4.3.3]
b. 14 Mar 1870 d. 1964
Lucy Frances Clark
b. 21 Apr 1878 d. 5 Apr 1939
10
Helen Waterman
[1.7.6.8.9.5.4.3.3.1]
b. 9 May 1898 d. 1976
Irving Edward Knight
b. 31 Aug 1897 d. 1953
11
Irving Waterman Knight
[1.7.6.8.9.5.4.3.3.1.1]
b. 21 Sep 1923 d. 7 Oct 2010
11
Robert Francis Knight
[1.7.6.8.9.5.4.3.3.1.2]
b. 19 Oct 1924 d. 15 Apr 1943
11
Marjorie Knight
[1.7.6.8.9.5.4.3.3.1.3]
b. 1 Apr 1934 d. 17 Oct 2011
+
William Thomas Sweetman
b. 10 Mar 1934 d. 19 Sep 2011
11
Living
[1.7.6.8.9.5.4.3.3.1.4]
+
Living
8
Elsie Jenks Carpenter
[1.7.6.8.9.5.4.4]
b. 5 Mar 1842
8
Charley Carpenter
[1.7.6.8.9.5.4.5]
b. 27 Jan 1847 d. 28 Nov 1872
7
Diana Jenckes
[1.7.6.8.9.5.5]
b. 7 Apr 1820 d. 4 Mar 1890
7
Albert Cheney Jenckes
[1.7.6.8.9.5.6]
b. 16 Mar 1822 d. 22 Dec 1887
7
Mary Humphry Jenckes
[1.7.6.8.9.5.7]
b. 24 Jan 1824 d. 17 Mar 1914
7
Charles Erastus Jenckes
[1.7.6.8.9.5.8]
b. 10 Oct 1825 d. 7 Apr 1896
7
Ardelia Jenckes
[1.7.6.8.9.5.9]
b. 9 Sep 1827 d. 8 Sep 1925
7
Henry Hartwell Jenckes
[1.7.6.8.9.5.10]
b. 14 Aug 1829
7
Nathaniel Miles Jenckes
[1.7.6.8.9.5.11]
b. 28 Aug 1831 d. 5 Jul 1892
7
George F Jenckes
[1.7.6.8.9.5.12]
b. 7 May 1834 d. 27 May 1922
5
Mary Jenckes
[1.7.6.8.10]
b. 3 Jun 1746 d. 15 Mar 1800
4
Phebe Sprague
[1.7.6.9]
b. Abt 1705 d. Sep 1778
3
Elizabeth Tilden
[1.7.7]
b. Abt 1665 d. 18 Feb 1712
3
Thomas Tilden
[1.7.8]
b. Abt 1668 d. Abt 10 Apr 1718
3
Stephen Tilden
[1.7.9]
b. Abt 1668
3
Hannah Tilden
[1.7.10]
b. Abt 1670 d. Aft 1705
3
Margery Tilden
[1.7.11]
b. 1674 d. Aft 1704
3
Experience Tilden
[1.7.12]
b. 1675 d. 18 Feb 1711
3
Susannah Tilden
[1.7.13]
b. Abt 1678 bur. 9 Sep 1684
3
John Tilden
[1.7.14]
b. Abt 1682 d. 20 Apr 1685
2
Judith Tilden
[1.8]
b. 22 Oct 1620 d. 30 Mar 1663
2
Winifred Tilden
[1.9]
b. 20 Oct 1622 d. 14 Sep 1627
2
Lydia Tilden
[1.10]
b. 30 May 1624 d. 15 Sep 1624