Home Page
|
What's New
|
Photos
|
Histories
|
Headstones
|
Reports
|
Surnames
Search
First Name:
Last Name:
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Suomalainen
Svenska
Elimore Staverton
Abt 1444 - 1505 (61 years)
Submit Photo / Document
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Submit Photo / Doc
Worksheet
Family
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Elimore Staverton
[1]
b. Abt 1444 d. 1505
Thomas Gould
b. Abt 1435 d. 5 May 1502
2
Thomas Gould
[1.1]
b. Abt 1455 d. 28 Sep 1520
Joan Curtis
b. Abt 1470 d. 12 Jan 1537
3
Richard Gould
[1.1.1]
b. 1479 d. 5 May 1531
3
Joan Curtis
[1.1.2]
b. 1480 d. 12 Jan 1537
3
Alice Gould
[1.1.3]
b. 1483
3
William Gould
[1.1.4]
b. 1484 d. Bef 8 May 1559
3
Henry Gould
[1.1.5]
b. 1486 d. 1520
3
Thomas Gould
[1.1.6]
b. 1500 d. Abt 28 Jun 1546
Alice Axtell Mandeville
b. 2 May 1499 d. 28 Jun 1546
4
John Gould
[1.1.6.1]
b. Abt 1523 d. 20 Nov 1602
4
Richard Gould
[1.1.6.2]
b. Abt 1530 d. Aft 4 Dec 1558
Jane Weden
b. Abt 1532 d. 10 Oct 1559
5
Richard Gould
[1.1.6.2.1]
b. 1553 d. 25 May 1597
Elizabeth Young
b. 1555 d. Aft 1589
6
Jeremy Gould
[1.1.6.2.1.1]
b. 26 Sep 1581 d. Jun 1654
6
Priscilla Gould
[1.1.6.2.1.2]
b. 3 Jun 1582 d. 30 Dec 1662
John Putnam
b. 1 Jan 1579 d. 30 Dec 1662
7
Elizabeth Putnam
[1.1.6.2.1.2.1]
b. 20 Dec 1612 d. 12 Dec 1692
7
Thomas Putnam
[1.1.6.2.1.2.2]
b. 7 Mar 1615 d. 5 May 1686
7
Nathaniel Putnam
[1.1.6.2.1.2.3]
b. 11 Oct 1619 d. 23 Jul 1700
7
Sarah Putnam
[1.1.6.2.1.2.4]
b. 7 Mar 1622 d. 27 Mar 1676
7
Phoebe Putnam
[1.1.6.2.1.2.5]
b. 28 Jul 1624 d. 30 Apr 1630
7
John Putnam
[1.1.6.2.1.2.6]
b. 27 May 1627 d. 7 Apr 1710
6
John Gould
[1.1.6.2.1.3]
b. Abt 1584 d. 11 Jul 1650
Judith Elizabeth Langley
b. 2 Jul 1588 d. 15 May 1650
7
Thomas Gould
[1.1.6.2.1.3.1]
b. 12 Jan 1606 d. 27 Oct 1675
Hannah Miller
b. 1617 d. 15 May 1674
8
Thomas Gould
[1.1.6.2.1.3.1.1]
b. Abt 1639 d. 1690
Elizabeth Thorndike
b. 1643 d. Abt 1690
9
Joseph Gould
[1.1.6.2.1.3.1.1.1]
b. 15 Jan 1662 d. 1710
Elizabeth Rea
b. 3 Jan 1660
10
Sarah Gould
[1.1.6.2.1.3.1.1.1.1]
b. 27 Jun 1688 d. 12 Jul 1688
10
Elizabeth Gould
[1.1.6.2.1.3.1.1.1.2]
b. 27 Jun 1688 d. 12 Jul 1688
10
Daniel Gould
[1.1.6.2.1.3.1.1.1.3]
b. 1 Dec 1691
10
Zerviah Gould
[1.1.6.2.1.3.1.1.1.4]
b. 20 Apr 1694 d. Bef 1741
John Sibley
b. 18 Sep 1687 d. 13 May 1741
11
Ebenezer Sibley
[1.1.6.2.1.3.1.1.1.4.1]
b. 28 Feb 1717 d. 4 Mar 1790
Abigail Cummings
b. 3 May 1716 d. 27 Sep 1783
12
Stephen Sibley
[1.1.6.2.1.3.1.1.1.4.1.1]
b. 12 Jul 1741 d. 25 Aug 1828 [
=>
]
12
Ebenezer Sibley
[1.1.6.2.1.3.1.1.1.4.1.2]
b. 9 Oct 1745 [
=>
]
12
Abigail Sibley
[1.1.6.2.1.3.1.1.1.4.1.3]
b. 22 Jan 1747
12
Peter Sibley
[1.1.6.2.1.3.1.1.1.4.1.4]
b. 16 Sep 1749
12
Mary Sibley
[1.1.6.2.1.3.1.1.1.4.1.5]
b. 20 Jan 1751
11
Stephen Sibley
[1.1.6.2.1.3.1.1.1.4.2]
b. 1 Oct 1720
Mrs Sibley
b. Abt 1725
12
Elias Sibley
[1.1.6.2.1.3.1.1.1.4.2.1]
b. Abt 1745
11
Bethiah Sibley
[1.1.6.2.1.3.1.1.1.4.3]
b. 2 Oct 1724 d. 1 Jul 1756
Samuel Trask
b. 17 Dec 1721 d. 7 Mar 1790
12
John Trask
[1.1.6.2.1.3.1.1.1.4.3.1]
b. 29 Sep 1744
12
Hannah Trask
[1.1.6.2.1.3.1.1.1.4.3.2]
b. 10 Nov 1746
12
Sarah Trask
[1.1.6.2.1.3.1.1.1.4.3.3]
b. 10 Sep 1753 d. 22 Aug 1830 [
=>
]
12
Samuel Trask, Jr
[1.1.6.2.1.3.1.1.1.4.3.4]
b. 26 Aug 1749 [
=>
]
12
Anne Trask
[1.1.6.2.1.3.1.1.1.4.3.5]
b. 9 Oct 1757
11
Timothy Sibley
[1.1.6.2.1.3.1.1.1.4.4]
b. 2 Nov 1727 d. 6 Dec 1818
Ann Waite
b. 14 Oct 1733 d. 12 Mar 1791
12
John Sibley
[1.1.6.2.1.3.1.1.1.4.4.1]
b. 19 May 1757 d. 8 Apr 1837 [
=>
]
12
Timothy Sibley
[1.1.6.2.1.3.1.1.1.4.4.2]
b. 19 Jun 1754 d. 26 Aug 1829 [
=>
]
12
Joshua Sibley
[1.1.6.2.1.3.1.1.1.4.4.3]
b. 16 Nov 1755 d. 29 Sep 1774
12
Stephen Sibley
[1.1.6.2.1.3.1.1.1.4.4.4]
b. 19 May 1757 d. 2 Jun 1759
12
Stephen Sibley
[1.1.6.2.1.3.1.1.1.4.4.5]
b. 10 Nov 1759 d. 21 Apr 1829
12
Ebenezer Sibley
[1.1.6.2.1.3.1.1.1.4.4.6]
b. 7 Apr 1761 d. 10 Sep 1839 [
=>
]
12
Anna Sibley
[1.1.6.2.1.3.1.1.1.4.4.7]
b. 15 Dec 1762 d. 17 Sep 1792 [
=>
]
12
Asa Sibley
[1.1.6.2.1.3.1.1.1.4.4.8]
b. 29 Mar 1764 d. 25 Feb 1829 [
=>
]
12
Jonathan Sibley
[1.1.6.2.1.3.1.1.1.4.4.9]
b. 8 May 1766 d. 20 Feb 1823 [
=>
]
12
Benjamin Sibley
[1.1.6.2.1.3.1.1.1.4.4.10]
b. 29 Apr 1768 d. 2 Oct 1829 [
=>
]
12
Soloman Sibley
[1.1.6.2.1.3.1.1.1.4.4.11]
b. 17 Nov 1769 [
=>
]
12
Polly Sibley
[1.1.6.2.1.3.1.1.1.4.4.12]
b. 4 Dec 1771 [
=>
]
12
Artamus Sibley
[1.1.6.2.1.3.1.1.1.4.4.13]
b. 9 Jul 1773 d. 10 Aug 1777
12
Nahum Sibley
[1.1.6.2.1.3.1.1.1.4.4.14]
b. 11 Sep 1775 d. 12 Sep 1796
12
Sally Sibley
[1.1.6.2.1.3.1.1.1.4.4.15]
b. 6 Jun 1779 d. 21 Mar 1833 [
=>
]
+
Hannah Amidon
b. Abt 1730 d. 5 Jun 1822
10
David Gould
[1.1.6.2.1.3.1.1.1.5]
b. 21 Apr 1694 d. 21 Apr 1694
10
Ebenezer Gould
[1.1.6.2.1.3.1.1.1.6]
b. 17 Oct 1696
10
Hannah Gould
[1.1.6.2.1.3.1.1.1.7]
b. 6 Nov 1698 d. Abt 1758
9
James Gould
[1.1.6.2.1.3.1.1.2]
b. 8 Feb 1667
Deborah Dudley
b. 11 Nov 1670
10
Mary Gould
[1.1.6.2.1.3.1.1.2.1]
b. 5 Jan 1692 d. 17 Jul 1767
10
James Gould
[1.1.6.2.1.3.1.1.2.2]
b. 20 Aug 1693 d. 1771
10
Benjamin Gould
[1.1.6.2.1.3.1.1.2.3]
b. 2 Oct 1695 d. 1765
10
Nathaniel Gould
[1.1.6.2.1.3.1.1.2.4]
b. 1697 d. 1746
10
Adams Gould
[1.1.6.2.1.3.1.1.2.5]
b. Abt 1711
10
Jerusha Gould
[1.1.6.2.1.3.1.1.2.6]
c. 29 Aug 1714
10
Mehitable Gould
[1.1.6.2.1.3.1.1.2.7]
c. 29 Aug 1714
10
Deborah Gould
[1.1.6.2.1.3.1.1.2.8]
c. 29 Aug 1714
9
Thomas Gould
[1.1.6.2.1.3.1.1.3]
b. 26 Feb 1668 d. 1 Feb 1732
Abigail Needham
b. 31 May 1671 d. 1716
10
Abigail Gould
[1.1.6.2.1.3.1.1.3.1]
b. 3 Aug 1692
10
Thomas Gould
[1.1.6.2.1.3.1.1.3.2]
b. 23 Jan 1694 d. 1732
10
Rachel Gould
[1.1.6.2.1.3.1.1.3.3]
b. 1696
10
George Gould
[1.1.6.2.1.3.1.1.3.4]
b. 1706 d. 29 Apr 1783
10
Mary Gould
[1.1.6.2.1.3.1.1.3.5]
b. 1708
10
Elizabeth Gould
[1.1.6.2.1.3.1.1.3.6]
b. Abt 1710 d. 1773
10
Ruth Gould
[1.1.6.2.1.3.1.1.3.7]
b. 1713 d. 1802
10
Nehemiah Gould
[1.1.6.2.1.3.1.1.3.8]
b. 15 Oct 1715
10
Provided Gould
[1.1.6.2.1.3.1.1.3.9]
b. 8 Jun 1721
9
Benjamin Gould
[1.1.6.2.1.3.1.1.4]
b. 26 Aug 1669 d. 17 May 1718
Elizabeth Robinson
b. 1662 d. 30 Sep 1745
10
Benjamin Gould
[1.1.6.2.1.3.1.1.4.1]
b. Abt 1687
10
Thomas Gould
[1.1.6.2.1.3.1.1.4.2]
b. 1688 d. 17 Jun 1746
10
Mary Gould
[1.1.6.2.1.3.1.1.4.3]
b. Abt 1689
10
John Gould
[1.1.6.2.1.3.1.1.4.4]
b. 1689 d. 25 May 1763
10
Ann Gould
[1.1.6.2.1.3.1.1.4.5]
b. Abt 1691
10
Nathaniel Gould
[1.1.6.2.1.3.1.1.4.6]
b. Abt 1695
10
Sarah Gould
[1.1.6.2.1.3.1.1.4.7]
b. Abt 1697
10
Ebenezer Gould
[1.1.6.2.1.3.1.1.4.8]
b. 1700 d. Abt 1778
10
David Gould
[1.1.6.2.1.3.1.1.4.9]
b. Abt 1701
10
Elizabeth Gould
[1.1.6.2.1.3.1.1.4.10]
b. Abt 1705
9
Samuel Gould
[1.1.6.2.1.3.1.1.5]
b. 6 Feb 1670 d. 12 Jun 1727
Elizabeth Thorndike
b. 14 Oct 1670 d. 12 Jun 1727
10
Elizabeth Gold
[1.1.6.2.1.3.1.1.5.1]
b. 15 Aug 1695 d. Abt 1695
10
Hannah Gould
[1.1.6.2.1.3.1.1.5.2]
b. 23 Nov 1701
10
Joseph Gould
[1.1.6.2.1.3.1.1.5.3]
b. 30 Nov 1702
10
Lydia Gould
[1.1.6.2.1.3.1.1.5.4]
b. 8 Aug 1706 d. 1750
10
Samuel Gould
[1.1.6.2.1.3.1.1.5.5]
b. 10 Mar 1708 d. Aft 1743
10
Paul Gould
[1.1.6.2.1.3.1.1.5.6]
b. 10 Mar 1708 d. 22 Mar 1709
10
Thomas Gould
[1.1.6.2.1.3.1.1.5.7]
b. 3 Jan 1711
10
Gideon Gould
[1.1.6.2.1.3.1.1.5.8]
b. 10 Dec 1710
9
Mary Gould
[1.1.6.2.1.3.1.1.6]
b. 1673 d. 1746
John Hutchinson
b. 26 Sep 1666 d. 1 Apr 1746
10
Son Hutchinson
[1.1.6.2.1.3.1.1.6.1]
b. Abt 1695 d. 1 Dec 1695
10
Mary Hutchinson
[1.1.6.2.1.3.1.1.6.2]
b. 2 Oct 1696
10
John Hutchinson
[1.1.6.2.1.3.1.1.6.3]
b. 31 Mar 1699 d. Aft Aug 1726
10
Ebenezer Hutchinson
[1.1.6.2.1.3.1.1.6.4]
b. 3 Jun 1705
10
Ermin Hutchinson
[1.1.6.2.1.3.1.1.6.5]
b. 9 Apr 1712
10
William Hutchinson
[1.1.6.2.1.3.1.1.6.6]
b. 16 Jan 1713 d. Abt 1757
10
Mehitabel Hutchinson
[1.1.6.2.1.3.1.1.6.7]
b. 24 May 1766 d. 29 Jun 1856
8
Hannah Gould
[1.1.6.2.1.3.1.2]
b. 11 Apr 1641
8
Jacob Gould
[1.1.6.2.1.3.1.3]
b. 16 Sep 1643
8
Mary Gould
[1.1.6.2.1.3.1.4]
b. 1645
8
Samuel Gould
[1.1.6.2.1.3.1.5]
b. 1647
8
Mehitable Gould
[1.1.6.2.1.3.1.6]
b. 1649
8
Thomas Gould
[1.1.6.2.1.3.1.7]
b. Abt 1650 d. 1709
8
Mary Gould
[1.1.6.2.1.3.1.8]
b. 1651
8
Anna Gould
[1.1.6.2.1.3.1.9]
b. Abt 1652
8
Abigail Gould
[1.1.6.2.1.3.1.10]
b. 1653
7
Mary Gould
[1.1.6.2.1.3.2]
b. 1610 d. 1674
7
Sarah Gould
[1.1.6.2.1.3.3]
b. 18 Sep 1614 d. Abt 1635
7
Nathaniel Gould
[1.1.6.2.1.3.4]
b. 1616 d. 12 Oct 1692
7
Hannah Gould
[1.1.6.2.1.3.5]
b. Abt 1617 d. Bef 1650
7
Zaccheus Gould
[1.1.6.2.1.3.6]
b. 1622 d. 1650
7
Nathan Gould
[1.1.6.2.1.3.7]
b. 1623 d. 4 Mar 1694
7
Abel Gould
[1.1.6.2.1.3.8]
b. 1624
7
Lydia Gould
[1.1.6.2.1.3.9]
b. 1626
7
Elizabeth Gould
[1.1.6.2.1.3.10]
b. 12 Dec 1627
6
Zaccheus Gould
[1.1.6.2.1.4]
b. 1 Oct 1589 d. 30 Mar 1668
Phebe Deacon
b. 3 Apr 1597 d. 20 Sep 1663
7
Phebe Gould
[1.1.6.2.1.4.1]
b. 27 Sep 1620 d. 7 May 1686
Thomas Perkins
b. 28 Apr 1622 d. 7 May 1686
8
John Perkins
[1.1.6.2.1.4.1.1]
b. Abt 1641 d. 19 May 1688
Deborah Browning
c. 31 Jan 1646 d. Aft 1704
9
Thomas Perkins
[1.1.6.2.1.4.1.1.1]
b. 4 May 1667 d. 3 Jun 1709
8
Phebe Perkins
[1.1.6.2.1.4.1.2]
b. 1644 d. 1680
Jacob Towne
c. 11 Mar 1632 d. 20 Feb 1713
9
Phebe Towne
[1.1.6.2.1.4.1.2.1]
b. 4 May 1666 d. 3 Jan 1669
9
Joanna Towne
[1.1.6.2.1.4.1.2.2]
b. 22 Jan 1668 d. 1736
+
Thomas Nichols
b. 20 Jan 1670 d. Aft 1725
9
Mary Towne
[1.1.6.2.1.4.1.2.3]
b. 27 Mar 1670 d. Aft 1695
+
Isaac Larrabee
b. 1663 d. May 1755
9
Susanna Towne
[1.1.6.2.1.4.1.2.4]
b. 24 Dec 1671 d. 13 Sep 1766
John Cummings
b. 7 Jun 1666 d. 3 Jul 1706
10
Joseph Cummings
[1.1.6.2.1.4.1.2.4.1]
b. Jan 1689 d. 22 Apr 1794
10
Sarah Cummings
[1.1.6.2.1.4.1.2.4.2]
b. 30 May 1690 d. Aft 1728
10
John Cummings
[1.1.6.2.1.4.1.2.4.3]
b. 12 Jun 1692
10
Isaac Cummings
[1.1.6.2.1.4.1.2.4.4]
b. 25 Dec 1695 d. Abt 1752
10
David Cummings
[1.1.6.2.1.4.1.2.4.5]
b. 15 Apr 1698 d. 2 Apr 1765
10
Mary Cummings
[1.1.6.2.1.4.1.2.4.6]
b. 13 May 1700 d. Bef 1732
10
Susannah Cummings
[1.1.6.2.1.4.1.2.4.7]
b. 13 Jan 1702 d. 1723
10
Hannah Cummings
[1.1.6.2.1.4.1.2.4.8]
c. 21 Dec 1718 d. 1718
9
Joseph Towne
[1.1.6.2.1.4.1.2.5]
b. 22 Mar 1673 d. 28 May 1757
9
Sarah Towne
[1.1.6.2.1.4.1.2.6]
b. 30 Dec 1675 d. 1 Nov 1760
9
John Towne
[1.1.6.2.1.4.1.2.7]
b. 20 Feb 1678 d. 28 Mar 1714
Abigail Stanley
b. 6 Aug 1688 d. 1 Sep 1743
10
John Towne
[1.1.6.2.1.4.1.2.7.1]
b. 5 Dec 1729 d. 9 Jan 1820
10
Abigail Towne
[1.1.6.2.1.4.1.2.7.2]
b. 29 Sep 1721 d. 8 Dec 1739
10
Catherine Towne
[1.1.6.2.1.4.1.2.7.3]
b. 14 Dec 1725
10
Bartholemew Towne
[1.1.6.2.1.4.1.2.7.4]
b. 4 Apr 1713 d. 9 May 1783
10
Samuel Towne
[1.1.6.2.1.4.1.2.7.5]
b. 1717 d. Nov 1778
10
Johnathan Towne
[1.1.6.2.1.4.1.2.7.6]
b. 5 Dec 1729 bur. Jul 1771
9
Martha Towne
[1.1.6.2.1.4.1.2.8]
b. 19 May 1680 d. 24 Feb 1753
+
Isaac Leach
b. Abt 1676
9
Phebe Towne
[1.1.6.2.1.4.1.2.9]
b. 23 Jul 1685 d. 10 Jun 1736
John Gould
b. 25 Aug 1687 d. 20 Jul 1762
10
John Gould
[1.1.6.2.1.4.1.2.9.1]
b. 9 Apr 1712 d. 18 Apr 1712
10
Kezia Gould
[1.1.6.2.1.4.1.2.9.2]
b. 10 May 1718 d. 28 Dec 1798
10
Stephen Gould
[1.1.6.2.1.4.1.2.9.3]
b. 6 Jul 1724 d. 1798
10
Ruth Gould
[1.1.6.2.1.4.1.2.9.4]
b. 16 Sep 1727 d. Not Needed
10
Esther Gould
[1.1.6.2.1.4.1.2.9.5]
b. 10 Aug 1732 d. 1785
8
Zaccheus Perkins
[1.1.6.2.1.4.1.3]
b. 1647 d. 1 Dec 1732
8
Thomas Perkins
[1.1.6.2.1.4.1.4]
b. Abt 1648 d. Apr 1722
Sarah Wallis
b. 24 Jul 1658 d. 1719
9
Thomas Perkins
[1.1.6.2.1.4.1.4.1]
b. 9 Dec 1688
9
Hannah Perkins
[1.1.6.2.1.4.1.4.2]
b. 1690 d. 1 Jan 1747
9
Robert Perkins
[1.1.6.2.1.4.1.4.3]
b. Abt 1695 d. 15 Jan 1750
9
Samuel Perkins
[1.1.6.2.1.4.1.4.4]
b. 18 May 1712 d. 1 Jan 1747
8
Martha Perkins
[1.1.6.2.1.4.1.5]
b. 1649 d. Abt 1728
John Lamson
b. Nov 1642 d. Bef 23 Jun 1717
9
John Lamson, Jr
[1.1.6.2.1.4.1.5.1]
b. 21 Nov 1669 d. 1 Sep 1760
9
Phebe Lamson
[1.1.6.2.1.4.1.5.2]
b. 13 Aug 1673 d. 23 May 1753
9
William Lamson
[1.1.6.2.1.4.1.5.3]
b. 19 Aug 1675 d. 1750
9
Martha Lamson
[1.1.6.2.1.4.1.5.4]
b. 21 Aug 1677 d. Abt 1724
9
Thomas Lamson
[1.1.6.2.1.4.1.5.5]
b. 3 Jan 1682 d. Jul 1767
9
Samuel Lamson
[1.1.6.2.1.4.1.5.6]
b. 25 Feb 1684 d. 17 Nov 1760
8
Mary Perkins
[1.1.6.2.1.4.1.6]
b. 1651 d. 1728
William Howlet
b. Abt 1650 d. 1718
9
John Howlet
[1.1.6.2.1.4.1.6.1]
b. Abt 1676 d. 7 Sep 1735
8
Judith Perkins
[1.1.6.2.1.4.1.7]
b. 11 Jul 1655 d. Abt 1743
Nathaniel Browne
b. 1645 bur. 13 Sep 1717
9
Nathaniel Brown
[1.1.6.2.1.4.1.7.1]
b. Abt 1676 d. Abt 12 Feb 1759
9
Elizabeth Brown
[1.1.6.2.1.4.1.7.2]
b. Abt 1678 d. Bef 1716
8
Elisha Perkins
[1.1.6.2.1.4.1.8]
b. 1656 d. 18 Feb 1741
Catharine Towne
b. 25 Feb 1662 d. 2 Jul 1714
9
Thomas Perkins
[1.1.6.2.1.4.1.8.1]
b. 15 Oct 1681 d. 1761
9
Elisha Perkins
[1.1.6.2.1.4.1.8.2]
b. 27 May 1683 d. 24 Dec 1704
9
John Perkins
[1.1.6.2.1.4.1.8.3]
b. 12 Aug 1685 d. 22 Jun 1750
9
Catharina Perkins
[1.1.6.2.1.4.1.8.4]
c. 3 Feb 1687
9
Phebe Perkins
[1.1.6.2.1.4.1.8.5]
b. 10 Aug 1690
9
Jacob B Perkins
[1.1.6.2.1.4.1.8.6]
c. 13 Nov 1692 d. 18 Nov 1758
9
Ruth Perkins
[1.1.6.2.1.4.1.8.7]
c. 10 May 1695 d. 9 Jun 1695
9
Mary Perkins
[1.1.6.2.1.4.1.8.8]
b. 30 Mar 1699 d. 1737
9
Joseph Perkins
[1.1.6.2.1.4.1.8.9]
b. 10 May 1702 d. 1777
8
Timothy Perkins
[1.1.6.2.1.4.1.9]
b. 6 Jun 1661 d. 18 Dec 1751
7
Mary Gould
[1.1.6.2.1.4.2]
b. 12 Dec 1621 d. 15 Nov 1690
John Reddington
b. Abt 1617 d. 15 Nov 1690
8
Daniel Reddingtion
[1.1.6.2.1.4.2.1]
b. 1645 d. 28 Sep 1732
8
Eliza Reddington
[1.1.6.2.1.4.2.2]
b. 1648
8
John Reddington
[1.1.6.2.1.4.2.3]
b. 20 Jun 1649 d. 8 Mar 1650
8
Mary Reddington
[1.1.6.2.1.4.2.4]
b. 4 May 1651 d. 13 Mar 1682
8
Phebe Reddington
[1.1.6.2.1.4.2.5]
b. 7 Apr 1655 d. 1 Oct 1696
8
Martha Reddington
[1.1.6.2.1.4.2.6]
b. 7 Apr 1655 d. 7 Aug 1731
8
Sarah Reddington
[1.1.6.2.1.4.2.7]
c. 12 Mar 1658 d. 8 Jul 1689
7
Martha Gould
[1.1.6.2.1.4.3]
b. 19 Jun 1623 d. Abt 1699
John Newmarch
b. 1619 d. 7 Mar 1696
8
John Newmarch
[1.1.6.2.1.4.3.1]
b. Abt 1649 d. 21 May 1733
8
Thomas Newmarch
[1.1.6.2.1.4.3.2]
b. Abt 1651 d. 9 Jul 1716
8
Sara Newmarch
[1.1.6.2.1.4.3.3]
b. Abt 1652 d. 1751
8
Phebe Newmarch
[1.1.6.2.1.4.3.4]
b. Abt 1652
8
Martha Newmarch
[1.1.6.2.1.4.3.5]
b. Abt 1652 d. 7 Jul 1720
8
Zaccheus Neumarch
[1.1.6.2.1.4.3.6]
b. Abt 1653 d. 1731
7
Priscilla Gould
[1.1.6.2.1.4.4]
b. 27 Sep 1628 d. 16 Sep 1663
John Wildes
b. 1620 d. 14 May 1705
8
Sarah Wildes
[1.1.6.2.1.4.4.1]
b. 1647 d. 12 May 1711
8
Elizabeth Wildes
[1.1.6.2.1.4.4.2]
b. 1653 d. 25 Jun 1718
Lieutenant Benjamin Jones
b. 31 Jul 1651 d. 25 Jun 1718
9
Lieutenant Thomas Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.1]
b. 13 Mar 1680 d. 4 Nov 1763
Mary Meacham
b. 12 Jan 1684 d. 8 Nov 1744
10
Mary Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.1]
b. 22 Apr 1709 d. 4 Nov 1780
Abraham Whipple
b. Abt 1709 d. 3 Oct 1768
11
Bathsheba Whipple
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.1.1]
b. 2 Feb 1731
11
Abraham Whipple, Jr
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.1.2]
b. 18 Mar 1734
11
Mary Whipple
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.1.3]
b. 1 Mar 1735 d. 6 Dec 1823
11
Samuel Whipple
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.1.4]
b. 7 Jan 1737 d. 28 Sep 1762
+
Oliver Evans
b. Abt 1741
11
Joseph Whipple
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.1.5]
b. 18 May 1740
Abigail Gary
b. 2 Jul 1743
12
Abraham Whipple
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.1.5.1]
b. 11 Feb 1768 d. 12 Jan 1852
11
Luther Whipple
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.1.6]
b. 7 Mar 1743 d. 1830
Eunice Gates
b. Abt 1744
12
Abram Whipple
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.1.6.1]
b. 11 Feb 1768 d. 12 Jan 1852 [
=>
]
12
Eunice Whipple
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.1.6.2]
b. 18 Mar 1770 d. 26 Feb 1863
12
Polly Whipple
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.1.6.3]
b. 1772 d. 24 Aug 1847 [
=>
]
12
Elizabeth Gates Whipple
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.1.6.4]
b. 19 Aug 1775 d. 26 Jun 1862 [
=>
]
12
Lydia Whipple
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.1.6.5]
b. 1777
12
Martha Whipple
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.1.6.6]
b. 1781
12
Clarissa Whipple
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.1.6.7]
b. 11 Mar 1784 [
=>
]
12
Henry Whipple
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.1.6.8]
b. Abt 1785 d. Aft 1800
12
Thomas Whipple
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.1.6.9]
b. 1787 d. 18 Sep 1887 [
=>
]
11
Anna Whipple
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.1.7]
b. 17 Feb 1744 d. 1811
Robert Follett
b. 27 Apr 1739 d. 9 Apr 1810
12
Robert Follett
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.1.7.1]
b. 15 Sep 1764 [
=>
]
12
Anna Follett
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.1.7.2]
b. 22 Mar 1766 d. 23 Apr 1839 [
=>
]
12
Mary Follett
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.1.7.3]
b. 10 Oct 1767 d. Bef 1810
12
Abigail Follett
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.1.7.4]
b. 18 Feb 1770 [
=>
]
12
Calvin Follett
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.1.7.5]
b. 6 Jan 1772 d. 21 Dec 1856 [
=>
]
12
Elijah Follett
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.1.7.6]
b. 29 Mar 1775 d. Jul 1816 [
=>
]
12
Samuel Follett
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.1.7.7]
b. 2 Apr 1776 [
=>
]
12
William Follett
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.1.7.8]
b. 3 Mar 1778 d. 1853 [
=>
]
12
Eunice Follett
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.1.7.9]
b. 28 Mar 1779 [
=>
]
12
John Follett
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.1.7.10]
b. 22 Aug 1783
11
Calvin Whipple
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.1.8]
b. 17 Aug 1745 d. 10 Nov 1762
11
Deborah Whipple
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.1.9]
b. 6 Aug 1747
11
Daniel Whipple
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.1.10]
b. 7 Sep 1749 d. 1798
Deborah Hildreth
b. 5 May 1755 d. Abt 1789
12
Samuel Whipple
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.1.10.1]
b. 1777 d. Aft 1800
12
Daniel Whipple
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.1.10.2]
b. 27 Aug 1779 d. 27 Sep 1839 [
=>
]
12
Richard Whipple
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.1.10.3]
b. Abt 1781 d. 25 May 1862
12
Roswell Whipple
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.1.10.4]
b. 1783 d. 25 May 1862 [
=>
]
12
Polly Whipple
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.1.10.5]
b. Abt 1785
12
Lucy Whipple
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.1.10.6]
b. Abt 1787
12
Cynthia Whipple
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.1.10.7]
b. 1789 d. 15 Feb 1856 [
=>
]
11
Thomas Whipple
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.1.11]
b. 16 Mar 1751 d. 1833
Lydia Gates
b. Abt 1761 d. 17 Mar 1795
12
Lydia Gates Whipple
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.1.11.1]
b. 24 Jul 1779 d. 1 Sep 1864 [
=>
]
12
Thomas Jefferson Whipple
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.1.11.2]
b. 1787 d. 23 Jan 1835 [
=>
]
12
Mattie Whipple
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.1.11.3]
b. 8 May 1789 d. 4 Sep 1877 [
=>
]
12
Son Whipple
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.1.11.4]
b. Bef 1790 d. Aft 1790
12
Walter Whipple
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.1.11.5]
b. 28 Feb 1792 d. 24 Dec 1882 [
=>
]
10
Jerusha Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.2]
b. 8 Apr 1711 d. 28 Oct 1763
Jonathan Spencer
b. 15 Mar 1704 d. 19 May 1763
11
Jerusha Spencer
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.2.1]
b. 6 May 1732 d. 21 Feb 1815
11
Jonathan Spencer
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.2.2]
b. 11 Mar 1734 d. 16 Jul 1813
11
Obadiah Spencer
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.2.3]
b. 7 Mar 1735 d. 1806
11
Ruth Spencer
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.2.4]
b. 12 Feb 1737
11
Israel Spencer
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.2.5]
b. 14 Feb 1740 d. 22 Sep 1747
11
Zachariah Spencer
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.2.6]
b. 28 Mar 1742 d. 4 Oct 1762
11
Jehid Spencer
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.2.7]
b. 17 Feb 1744 d. 16 Sep 1747
11
Jehiel Spencer
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.2.8]
b. 17 Feb 1747 d. 24 Feb 1816
11
Israel Spencer
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.2.9]
b. Abt 1748 d. 22 Jan 1825
11
Hulda Spencer
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.2.10]
b. 7 Jan 1750
11
Sybil Spencer
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.2.11]
b. 17 Mar 1759
10
Thomas Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.3]
b. 15 Mar 1712 d. 1746
+
Sarah Parsons
b. 10 Mar 1704 d. 25 Aug 1747
10
Bathsheba Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.4]
b. 16 Feb 1714 d. 12 May 1715
10
Captain Israel Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.5]
b. 18 May 1715 d. 28 Dec 1798
Jemima Clark
b. 5 Mar 1726 d. 3 Jun 1798
11
Israel Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.5.1]
b. 2 Sep 1753 d. 1 Sep 1812
11
Jemima Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.5.2]
b. 5 Jun 1755 d. 22 Dec 1818
11
Samuel Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.5.3]
b. 31 Jan 1745 d. 4 Sep 1747
11
William Clark Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.5.4]
b. Abt 1771
11
Thomas Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.5.5]
b. 1751 d. 1832
11
Mary Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.5.6]
b. Abt 1745 d. Abt 1826
11
Isaac Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.5.7]
b. 25 Apr 1764 d. 16 Jul 1830
11
Submit Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.5.8]
b. 18 Oct 1757 d. 29 Dec 1785
10
Isaac Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.6]
b. 29 Jan 1717 d. 3 Jul 1784
+
Elizabeth
b. Abt 1718
10
Bathsheba Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.7]
b. 25 Feb 1720 d. 9 Jan 1775
John Pease
b. 1726 d. Abt 1810
11
John Chauncey Pease
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.7.1]
b. Abt 1750 d. 1843
11
Thomas Pease
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.7.2]
c. 17 Dec 1754 d. 2 Feb 1810
11
Gideon Pease
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.7.3]
b. 18 Nov 1757 d. 1824
11
Elizabeth Pease
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.7.4]
b. 29 May 1756 d. 24 Sep 1827
11
Bathsheba Pease
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.7.5]
b. 1759
11
Sarah Pease
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.7.6]
b. 14 May 1762
11
Simeon Pease
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.7.7]
b. Abt 1764 d. 1827
10
Elizabeth Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.8]
b. 1722 d. 1804
David Kellogg
b. Abt 1718 d. 6 Mar 1747
11
Mary Kellogg
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.8.1]
b. 13 Jun 1748 d. 20 Jun 1810
11
Samuel Kellogg
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.8.2]
b. 6 Aug 1749
11
David Kellogg
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.8.3]
b. 16 Nov 1750 d. 22 Apr 1774
11
Elizabeth Kellogg
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.8.4]
b. 15 Aug 1752 d. 15 Mar 1807
11
Seth Kellogg
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.8.5]
b. 14 Mar 1754 d. 20 Jun 1801
11
Phineas Kellogg
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.8.6]
b. 6 Apr 1756 d. 26 Jul 1806
11
Ruth Kellogg
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.8.7]
b. 3 Sep 1757 d. 14 Jun 1837
11
Enoch Kellogg
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.8.8]
b. 12 Jul 1759 d. 31 Aug 1759
11
Elzina Kellogg
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.8.9]
b. Abt 1761
11
Lucretia Kellogg
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.8.10]
b. Abt 1763 d. 14 Jun 1814
11
Enoch Kellogg
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.8.11]
b. 9 Oct 1768 d. 29 Oct 1847
10
Samuel Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.9]
b. 29 Oct 1724 d. 19 Sep 1743
+
Anna Taylor
b. Abt 1727
10
Son Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.1.10]
b. Abt 1726
9
Priscilla Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.2]
b. 10 Jun 1681 d. Aft 1719
John Howard
b. 1683
10
Elezebath Howard
[1.1.6.2.1.4.4.2.2.1]
b. 20 May 1707
10
Priscilla Howard
[1.1.6.2.1.4.4.2.2.2]
b. 20 Sep 1705 bur. Abt 1759
10
John Howard
[1.1.6.2.1.4.4.2.2.3]
b. 24 May 1719
9
Benjamin Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.3]
b. 1683 d. 5 Feb 1754
Anna Prior
b. 30 Mar 1690 d. 5 Feb 1754
10
Benjamin Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.3.1]
b. 9 Jun 1710 d. 13 Oct 1794
10
Joseph Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.3.2]
b. 3 Jan 1712 d. 26 Jan 1757
Sarah Wood
b. Abt 1712
11
Joseph Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.3.2.1]
b. 1 Nov 1734 d. 29 Jan 1816
Sarah Mead
b. 10 Aug 1735 d. 21 Dec 1822
12
Thomas Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.3.2.1.1]
b. 1762 d. 25 Jul 1842 [
=>
]
11
Tryphena Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.3.2.2]
b. 22 Mar 1737
11
Silas Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.3.2.3]
b. 1 Apr 1740
11
Daniel Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.3.2.4]
b. 31 Jan 1743 d. 23 Mar 1792
11
Esther Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.3.2.5]
b. Abt 1757 d. 1821
10
Annie Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.3.3]
b. 9 Sep 1714 d. 22 Sep 1808
10
Levi Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.3.4]
b. 9 Nov 1716 d. 23 May 1766
10
Abi Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.3.5]
b. 15 Mar 1718
10
Hannah Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.3.6]
b. 23 Sep 1720 d. 11 Oct 1806
10
Naomi Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.3.7]
b. 28 Mar 1721
10
Zebblon Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.3.8]
b. 9 Jun 1723 d. 27 Sep 1776
10
Lucrettia Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.3.9]
b. 1729
9
Ebenezer Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.4]
b. 17 Apr 1684 d. 20 Jul 1755
Priscilla Smith
b. Abt 1684 d. Bef 1725
10
Elezebath Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.4.1]
b. 11 May 1713
10
Ebenezer Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.4.2]
b. 12 Jan 1715
10
Gersham Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.4.3]
b. 1717
10
Hannah Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.4.4]
b. 11 Jul 1720 d. 8 Jul 1764
10
Martha Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.4.5]
b. Abt 1721
Jemima Gary
b. 10 Mar 1705 d. Aft 1747
10
North Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.4.6]
b. 18 Apr 1731
10
Zerviah Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.4.7]
b. 28 Mar 1734
10
Abigail Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.4.8]
b. 4 Jan 1735
10
Nathan Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.4.9]
b. Jun 1738
10
Thomas Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.4.10]
b. 30 Aug 1741 d. 13 Oct 1762
10
Margan Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.4.11]
b. 8 Aug 1747
9
Elizabeth Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.5]
b. 26 Jan 1685 d. 2 Jan 1769
Isaac Osborn
b. Abt 1680
10
George Osborn
[1.1.6.2.1.4.4.2.5.1]
c. 20 Oct 1724
9
Ephraim Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.6]
b. 31 Jul 1688 d. 3 Sep 1688
9
Samuel Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.7]
b. 22 Sep 1690 d. 4 Nov 1691
9
Eleazer Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.8]
b. 12 Apr 1693 d. 20 Apr 1755
Mehitable Gary
b. 11 Jul 1697 d. Aft 1735
10
Son Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.8.1]
b. 21 May 1721 d. 26 Jun 1721
10
Eleazer Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.8.2]
b. 26 Jan 1723 d. 23 May 1758
10
Mehitable Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.8.3]
b. 4 Jun 1725 d. 28 Apr 1766
10
Elizabeth Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.8.4]
b. 23 Jul 1727 d. 28 Apr 1766
10
Benjamin Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.8.5]
b. 8 May 1730
10
Ebenezer Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.8.6]
9
Gersham Jones
[1.1.6.2.1.4.4.2.9]
b. 26 Oct 1695 d. 19 Oct 1696
8
Priscilla Wildes
[1.1.6.2.1.4.4.3]
b. 6 Apr 1658 d. 23 Mar 1688
8
Martha Wildes
[1.1.6.2.1.4.4.4]
b. 13 May 1660 d. 1685
8
Nathan Wildes
[1.1.6.2.1.4.4.5]
b. 14 Dec 1662 d. 17 Mar 1663
7
John Gould
[1.1.6.2.1.4.5]
b. 21 Jun 1635 d. 26 Jan 1710
Sarah Baker
b. 9 Mar 1641 d. 20 Jan 1709
8
John Gould
[1.1.6.2.1.4.5.1]
b. 1 Dec 1662 d. 5 Nov 1724
8
Sarah Gould
[1.1.6.2.1.4.5.2]
b. 18 Dec 1664 d. 4 Dec 1723
8
Thomas Gould
[1.1.6.2.1.4.5.3]
b. 14 Feb 1666 d. 24 Jun 1752
8
Samuel Gould
[1.1.6.2.1.4.5.4]
b. 9 Mar 1669 d. 1 Dec 1724
8
Zaccheus Gould
[1.1.6.2.1.4.5.5]
b. 26 Mar 1672 d. 29 Apr 1739
Elizabeth Curtis
b. 15 Dec 1679 d. 21 Jun 1740
9
Elizabeth Gould
[1.1.6.2.1.4.5.5.1]
b. 3 Feb 1703 d. 17 Sep 1742
Edmund Towne
b. 7 May 1699 d. 27 May 1745
10
Eliza Goold
[1.1.6.2.1.4.5.5.1.1]
b. 29 Dec 1723
10
Debora Goold
[1.1.6.2.1.4.5.5.1.2]
b. Abt 1724 d. 12 Mar 1812
10
Mehitabel Goold
[1.1.6.2.1.4.5.5.1.3]
b. 10 Nov 1728
10
Edmund Towne
[1.1.6.2.1.4.5.5.1.4]
b. 10 Sep 1733
10
Nathaniel Gould
[1.1.6.2.1.4.5.5.1.5]
b. 17 Nov 1734 d. Dec 1781
10
Zaccheus Town
[1.1.6.2.1.4.5.5.1.6]
b. 20 Feb 1736 d. 1740
10
Bathsheba Towne
[1.1.6.2.1.4.5.5.1.7]
b. 28 Mar 1740 d. 1741
10
Mary Towne
[1.1.6.2.1.4.5.5.1.8]
b. 7 Sep 1742 d. 1742
9
Mary Gould
[1.1.6.2.1.4.5.5.2]
c. 1 Mar 1704 d. 3 Nov 1787
9
John Gould
[1.1.6.2.1.4.5.5.3]
b. 29 Jan 1709 d. 21 Jun 1778
9
Sarah Gould
[1.1.6.2.1.4.5.5.4]
b. 28 Jan 1711 d. 1743
9
Abigail Gould
[1.1.6.2.1.4.5.5.5]
b. 12 Aug 1715 d. Abt 1737
9
Zaccheus Gould
[1.1.6.2.1.4.5.5.6]
b. 7 Nov 1717 d. 2 Jan 1793
9
Eleazar Gould
[1.1.6.2.1.4.5.5.7]
b. 29 May 1720 d. Jun 1795
Elizabeth Smith
b. 8 Jul 1718 d. 27 Mar 1753
10
Zaccheus Gould
[1.1.6.2.1.4.5.5.7.1]
b. 5 Feb 1743 d. 13 Feb 1823
10
John Gould
[1.1.6.2.1.4.5.5.7.2]
b. 5 Mar 1745
10
Hulda Gould
[1.1.6.2.1.4.5.5.7.3]
b. 1 Aug 1748 d. 11 Oct 1748
9
Susannah Gould
[1.1.6.2.1.4.5.5.8]
b. 19 Feb 1723 d. Abt 1773
Robert Smith
b. 28 Feb 1724 d. 17 Mar 1795
10
Elijah Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.8.1]
b. 5 Dec 1746 d. 5 Nov 1839
10
Elisha Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.8.2]
b. 4 Oct 1748
10
Joseph Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.8.3]
b. 9 Jun 1751
10
Elizabeth Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.8.4]
b. 20 Apr 1753 d. 10 Apr 1797
10
Rebeckah Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.8.5]
b. 8 May 1758 d. 8 Sep 1839
10
Thomas Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.8.6]
b. 10 Mar 1760 d. 3 Oct 1846
10
Silas Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.8.7]
b. 30 May 1772
10
Jedediah Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.8.8]
b. 30 May 1772
9
Priscilla Gould
[1.1.6.2.1.4.5.5.9]
b. 4 Aug 1707 d. 25 Sep 1744
Captain Samuel T Smith
b. 26 Jan 1714 d. 14 Nov 1785
10
Priscilla Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.1]
b. 26 Dec 1735 d. 7 Dec 1792
Jacob Kimball
b. 5 Mar 1731 d. 8 Nov 1810
11
Benjamin Kimball
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.1.1]
b. 23 Jan 1757 d. 19 Aug 1776
11
Mehetiball Kimbal
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.1.2]
b. 3 Dec 1758 d. 12 Nov 1790
11
Jacob Kimball
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.1.3]
b. 2 Feb 1761 d. 24 Jul 1826
11
Priscilla Kimball
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.1.4]
b. 10 Mar 1763 d. 2 Sep 1792
11
Ann Kimball
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.1.5]
b. 2 Jun 1765 d. 12 Sep 1789
11
Lucy Kimball
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.1.6]
b. 6 Sep 1767 bur. Sep 1790
11
Lydia Kimball
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.1.7]
b. 28 Jan 1770 d. 20 Apr 1795
11
David Kimball
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.1.8]
b. 26 Apr 1772 d. 20 Nov 1795
11
Samuel Kimball
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.1.9]
b. Dec 1774 d. 10 Sep 1775
10
Samuel Smith, III
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.2]
b. 28 Oct 1737 d. 14 Nov 1785
Rebecca Lovett
b. 9 Jun 1737 d. Aft 1760
11
Rebekah Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.2.1]
b. 29 Jun 1760 d. 15 Apr 1816
11
Lydia Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.2.2]
b. 14 Apr 1762 d. 19 Dec 1850
Jacob Wilds
b. Abt 1780 d. 16 Jan 1841
12
Mary Wilds
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.2.2.1]
b. Sep 1787 d. 29 Feb 1856
12
Moses Wilds
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.2.2.2]
b. 8 Oct 1790 d. 1 Nov 1879 [
=>
]
12
Asa Wilds
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.2.2.3]
b. Abt 1795 d. Abt 1831
12
Nancy Wilds
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.2.2.4]
b. 12 May 1798 d. 4 Dec 1884
12
William Wilds
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.2.2.5]
b. 16 Jan 1800 d. 16 Feb 1876 [
=>
]
12
Susan Wilds
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.2.2.6]
b. 16 Mar 1803 d. 18 Jan 1869
11
Susanna Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.2.3]
b. 9 Mar 1764 d. 18 Sep 1781
11
Samuel Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.2.4]
b. 1 Apr 1766 d. 21 Mar 1811
11
Elizabeth Mary Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.2.5]
b. 31 Mar 1768
11
Jacob Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.2.6]
b. 24 May 1770
11
Anna Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.2.7]
b. 8 Jan 1772
11
Son Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.2.8]
b. 13 Apr 1773
11
Benjamin Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.2.9]
b. 20 Feb 1776 d. 2 Oct 1778
10
Vashti Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.3]
b. 5 Oct 1739 d. Aft 1776
Jacobs Hobbs
b. 16 Jun 1745 d. 20 Jan 1823
11
Jacob Hobbs
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.3.1]
b. 21 Feb 1768
11
Abraham Hobbs
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.3.2]
b. 16 Dec 1769
11
Samuel Hobbs
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.3.3]
b. 21 Feb 1772
11
Vashti Hobbs
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.3.4]
b. 2 Feb 1774 d. 14 Feb 1836
11
Abigail Hobbs
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.3.5]
b. 10 Aug 1776
Soloman Curtis
b. 10 Jul 1739 d. Apr 1766
11
Solomon Curtis
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.3.6]
b. 13 Apr 1766
10
Susannah Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.4]
b. 24 Jan 1741 d. 13 May 1766
Isaac Hobbs
b. 20 Apr 1743 d. 3 Jun 1815
11
Sarah Hobbs
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.4.1]
b. 16 Nov 1766 d. 27 Jan 1823
11
Susannah Hobbs
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.4.2]
b. 16 Nov 1766 d. Abt 1870
11
Priscilla Hobbs
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.4.3]
b. 28 May 1769 d. 18 May 1771
11
Isaac Hobbs
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.4.4]
b. 19 Aug 1770 d. Abt 1870
11
Elizabeth Hobbs
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.4.5]
b. 16 Jan 1773 d. 14 Nov 1850
11
Munson Hobbs
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.4.6]
b. 5 Mar 1775 d. Abt 1870
11
Samuel Hobbs
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.4.7]
b. 1 Dec 1776 d. Abt 1870
11
Humphrey Hobbs
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.4.8]
b. 5 Sep 1779 d. Abt 1870
11
Solomon Hobbs
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.4.9]
b. 1782 d. 2 May 1854
10
Asael Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5]
b. 7 Mar 1744 d. 31 Oct 1830
Mary Elizabeth Duty
b. 11 Oct 1743 d. 27 May 1836
11
Jesse Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.1]
b. 20 Apr 1768 d. 16 Mar 1793
Hannah Peabody
b. 1771 d. 28 Sep 1849
12
Benjamin Peabody Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.1.1]
b. 2 May 1793 d. 15 Jan 1850 [
=>
]
12
Eliza Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.1.2]
b. 9 Mar 1795 d. 22 Jul 1870 [
=>
]
12
Ira Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.1.3]
b. 30 Jan 1797 d. 5 Mar 1874 [
=>
]
12
Harvey Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.1.4]
b. 1 Apr 1799 d. 20 Feb 1872 [
=>
]
12
Harriet Tupper Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.1.5]
b. 8 Apr 1801 d. Apr 1879
12
Stephen Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.1.6]
b. 2 May 1803 d. 16 Apr 1851
12
Mary Polly Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.1.7]
b. 4 May 1805 d. 13 Jun 1870
12
Catherine Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.1.8]
b. 13 Jul 1807 d. 2 May 1888 [
=>
]
12
Royal Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.1.9]
b. 2 Jul 1809 d. 1882
12
Sarah B Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.1.10]
b. 16 Dec 1810 d. 2 Oct 1887
+
Christene Smith
11
Priscilla Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.2]
b. 21 Oct 1769 d. 17 Apr 1860
John Curtis Waller
12
Calvin C. Waller
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.2.1]
b. 6 Jun 1797 d. Jun 1864
12
Dolly Waller
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.2.2]
b. 16 Oct 1799 d. 20 Jun 1800
12
Marshall Waller
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.2.3]
b. 18 Mar 1801
12
Royal H Waller
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.2.4]
b. 29 Nov 1802 d. 29 Sep 1866
12
Dudley C Waller
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.2.5]
b. 29 Sep 1804 d. Abt 1868
12
Bushrod W Waller
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.2.6]
b. 18 Oct 1806
12
Silas Waller
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.2.7]
b. 1 Jan 1809 d. 2 Jun 1866 [
=>
]
12
Salley P Waller
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.2.8]
b. 31 Oct 1810 d. 15 Aug 1874
12
John J Waller
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.2.9]
b. 9 Sep 1812 d. 5 Nov 1812
+
Michael Smith
11
Joseph Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.3]
b. 12 Jul 1771 d. 14 Sep 1840
Lucy Mack
b. 8 Jul 1775 d. 14 May 1856
12
Son Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.3.1]
b. 1797 d. 1797
12
Daughter Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.3.2]
b. 1797 d. 1797
12
Alvin Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.3.3]
b. 11 Feb 1798 d. 19 Nov 1823
12
Hyrum Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.3.4]
b. 9 Feb 1800 d. 27 Jun 1844 [
=>
]
12
Sophronia Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.3.5]
b. 17 May 1803 d. 28 Oct 1876 [
=>
]
12
Samuel Harrison Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.3.6]
b. 13 Mar 1808 d. 30 Jul 1844 [
=>
]
12
Ephraim Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.3.7]
b. 13 Mar 1810 d. 24 Mar 1810
12
William B Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.3.8]
b. 13 Mar 1811 d. 13 Nov 1893 [
=>
]
12
Katherine Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.3.9]
b. 28 Jul 1813 d. 1 Feb 1900 [
=>
]
12
Don Carlos Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.3.10]
b. 25 Mar 1816 d. 7 Aug 1841 [
=>
]
12
Lucy Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.3.11]
b. 18 Jul 1821 d. 9 Dec 1882 [
=>
]
12
Joseph Smith, Jr
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.3.12]
b. 23 Dec 1805 d. 27 Jun 1844 [
=>
]
11
Asahel Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.4]
b. 21 May 1773 d. 21 Jul 1848
Elizabeth Shellenger
b. 1 Dec 1785 d. 14 Oct 1846
12
Elias Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.4.1]
b. 6 Sep 1804 d. 24 Jun 1888 [
=>
]
12
Emily Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.4.2]
b. 1 Sep 1806 d. 11 Aug 1893 [
=>
]
12
Jessie Johnson Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.4.3]
b. 6 Oct 1808 d. 1 Jul 1834 [
=>
]
12
Esther Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.4.4]
b. 20 Sep 1810 d. 31 Oct 1856 [
=>
]
12
Mary Jane Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.4.5]
b. 29 Apr 1815 d. 1 Mar 1878 [
=>
]
12
Julia Priscilla Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.4.6]
b. 4 Mar 1815 d. 14 Aug 1906 [
=>
]
12
Silas Schellinger Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.4.7]
b. 6 Jun 1822 d. 11 Jun 1892 [
=>
]
12
Martha Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.4.8]
b. 9 Jun 1817 d. 12 Oct 1902 [
=>
]
+
Jane Smith
b. 1775
11
Mary Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.5]
b. 4 Jun 1775 d. 24 May 1844
Isaac Pierce
b. 11 Oct 1773 d. 9 Nov 1847
12
Eunice Pierce
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.5.1]
b. 29 Apr 1799 d. 9 Jun 1803
12
Laura Pierce
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.5.2]
b. 12 Nov 1801 d. 1803
12
Miranda Pierce
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.5.3]
b. 17 Jun 1803 d. 16 Sep 1831
12
Horace Pierce
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.5.4]
b. 8 Jun 1805 d. 20 May 1877
12
John S. Pierce
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.5.5]
b. 6 Jun 1807 d. 3 Apr 1854
12
Susan Pierce
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.5.6]
b. 20 Jun 1809 d. 4 Apr 1855
12
Mary Pierce
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.5.7]
b. 25 Apr 1811
12
Elisabeth Ann Pierce
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.5.8]
b. 2 Sep 1817 d. 16 May 1855
+
Joseph Brimhall
b. 1771
+
Charles Smith
b. 1772
11
Samuel Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.6]
b. 15 Sep 1777 d. 1 Apr 1830
Frances Wilcox
b. 1780
12
Charles Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.6.1]
b. 16 Apr 1817
12
Laura Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.6.2]
b. 1 Mar 1819
12
Horace Jay Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.6.3]
b. 12 Jul 1821
12
Sarah Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.6.4]
b. 11 Jun 1824
12
Elizabeth Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.6.5]
b. 16 Jul 1826
11
Silas Sanford Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.7]
b. 1 Oct 1779 d. 13 Sep 1839
Ruth Steven
b. 1782 d. 10 Jan 1864
12
Charles Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.7.1]
b. 11 Nov 1806 d. 7 May 1809
12
Charity Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.7.2]
b. 1 Apr 1808 d. 2 Jun 1888
12
Curtis Stevens Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.7.3]
b. 29 Oct 1809 d. 23 Sep 1861 [
=>
]
12
Samuel Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.7.4]
b. 3 Oct 1811 d. 7 Mar 1826
12
Stephen Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.7.5]
b. 8 Jan 1815 d. 20 Feb 1891
12
Susan Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.7.6]
b. 19 Oct 1817 d. 20 Nov 1846
12
Asahel Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.7.7]
b. 12 Oct 1819 d. 15 May 1834
Mary Aikens
b. 13 Aug 1797 d. 27 Apr 1877
12
Silas Sanford Smith, Jr
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.7.8]
b. 26 Oct 1830 d. 11 Oct 1910 [
=>
]
12
John Aikens Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.7.9]
b. 6 Jul 1832 d. 27 Nov 1838
12
Jesse Nathaniel Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.7.10]
b. 2 Dec 1834 d. 5 Jun 1906 [
=>
]
11
Patriarch John Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.8]
b. 16 Jul 1781 d. 23 May 1854
Clarissa Loomis Lyman
b. 27 Jun 1790 d. 14 Feb 1854
12
Daughter Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.8.1]
b. 9 May 1816 d. 9 May 1816
12
George Albert Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.8.2]
b. 26 Jun 1817 d. 1 Sep 1875 [
=>
]
12
Caroline Clara Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.8.3]
b. 6 Jun 1820 d. 8 Jan 1895 [
=>
]
12
John Lyman Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.8.4]
b. 17 Nov 1828 d. 21 Feb 1898
11
Susannah Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.9]
b. 18 May 1783 d. 22 Mar 1849
+
John Hall
11
Stephen Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.10]
b. 23 Apr 1785 d. 25 Jul 1802
+
Sally Hadley
11
Sarah Smith
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.11]
b. 16 May 1789 d. 27 May 1824
Joseph Sanford
b. 1785 d. 11 Sep 1825
12
Martin Sanford
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.11.1]
b. 24 Sep 1811 d. 24 Nov 1817
12
Martin Sanford
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.11.2]
b. 4 Nov 1812 d. 3 Dec 1820
12
Joseph Sanford
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.11.3]
b. 1813 d. 1816
12
Charlette Sanford
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.11.4]
b. 4 Mar 1814 d. Abt 1858
12
William Wallace Sanford
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.11.5]
b. 13 Jun 1816 d. 1844
12
John Lyman Sanford
[1.1.6.2.1.4.5.5.9.5.11.6]
b. 20 May 1818
8
Priscilla Gould
[1.1.6.2.1.4.5.6]
b. 2 Nov 1674 d. 16 Jun 1715
8
Captain Joseph Gould
[1.1.6.2.1.4.5.7]
b. 24 Aug 1677 d. 4 Apr 1753
8
Mary Gould
[1.1.6.2.1.4.5.8]
b. 16 Jun 1681 d. 11 May 1689
5
Henry Gould
[1.1.6.2.2]
b. Abt 1555 d. 1605
Alice Henninton
b. Abt 1553 d. 10 Apr 1603
6
Henry Gould
[1.1.6.2.2.1]
b. Abt 1573 d. 29 Jul 1615
6
John Gould
[1.1.6.2.2.2]
b. Abt 1575
4
Bridget Gould
[1.1.6.3]
b. Abt 1536
3
John Gould
[1.1.7]
b. 1500 d. 1520
3
Henry Gould
[1.1.8]
b. 1506 d. 1520
3
Joan Gould
[1.1.9]
b. Abt 1508
3
Sybil Gould
[1.1.10]
b. Abt 1522 d. 30 Apr 1571
Robert Fiske
b. 1525 d. 28 Jul 1600
4
Richard Fiske
[1.1.10.1]
c. 16 Jun 1554
4
William Fiske
[1.1.10.2]
b. Abt 1556 d. 17 May 1623
Anna Anstye
b. 1553 d. 17 May 1620
5
John Fiske
[1.1.10.2.1]
b. Abt 1572 bur. 14 May 1633
5
Eleazer Fiske
[1.1.10.2.2]
b. 1578
5
Eunice Fiske
[1.1.10.2.3]
b. Abt 1580 d. 25 Nov 1616
5
Hannah Anne Fiske
[1.1.10.2.4]
b. 1582 d. 25 Nov 1616
5
Hester Fiske
[1.1.10.2.5]
b. 1584
5
John Fiske
[1.1.10.2.6]
b. 1592 bur. 14 May 1633
5
Mary Anne Fiske
[1.1.10.2.7]
b. 16 Apr 1593 d. Abt 1663
4
Thomas Fiske
[1.1.10.3]
b. 1560 d. 28 Feb 1610
+
Margery Annis
b. 1562 d. 1611
4
Jeffrey Fiske
[1.1.10.4]
b. 1568 d. 23 Jul 1629
Mary Sarah Cooke
b. Abt 1568 d. 14 May 1614
5
Samuel Fiske
[1.1.10.4.1]
b. Abt 1586 d. Aft Jul 1629
5
Nathaniel Fiske
[1.1.10.4.2]
b. Abt 1588 d. 13 Sep 1601
5
Mary Fiske
[1.1.10.4.3]
b. Abt 1590
+
John Moore
b. Abt 1590
5
Nathan Fiske
[1.1.10.4.4]
b. Abt 1592 d. 21 Jun 1676
Susanna Browne
b. 4 Sep 1617 d. 1 Mar 1693
6
Lieutenant Nathan Fiske
[1.1.10.4.4.1]
b. 17 Oct 1642 d. 11 Oct 1694
6
Susan Fiske
[1.1.10.4.4.2]
b. 1644
6
John Fiske
[1.1.10.4.4.3]
b. 25 Aug 1647 d. 11 Jun 1679
6
David Fiske
[1.1.10.4.4.4]
b. 29 Apr 1650 d. Abt 10 Dec 1694
6
Sarah Fiske
[1.1.10.4.4.5]
b. 1 Feb 1652 d. 14 May 1728
6
Nathaniel Fiske
[1.1.10.4.4.6]
b. 12 Jul 1653 d. 23 Sep 1735
5
Clara Fiske
[1.1.10.4.5]
b. 10 Mar 1594
5
Eleazar Fiske
[1.1.10.4.6]
b. Abt 1594 d. Abt 1597
5
Lydia Fiske
[1.1.10.4.7]
b. Abt 1595
+
Thomas Harris
5
Anne Fiske
[1.1.10.4.8]
b. Abt 1596
William Bird
b. Abt 1592
6
Sarah Bird
[1.1.10.4.8.1]
b. Abt 1618
6
William Bird
[1.1.10.4.8.2]
b. Abt 1620
6
Bartholomew Bird
[1.1.10.4.8.3]
b. Abt 1622
6
Thomas Bird
[1.1.10.4.8.4]
b. Abt 1624
6
Sarah Bird
[1.1.10.4.8.5]
b. Abt 1630
6
William Bird
[1.1.10.4.8.6]
b. 1632
5
David Fiske
[1.1.10.4.9]
b. Abt 1597 d. 22 Jan 1662
Sarah Smith
b. Abt 1604 d. 10 Jan 1680
6
Sarah Fiske
[1.1.10.4.9.1]
b. 29 Nov 1621 bur. 29 Sep 1625
6
David Fiske
[1.1.10.4.9.2]
b. 18 Dec 1623 d. 14 Feb 1710
Seaborn Wilson
b. 1636 d. 12 Jan 1721
7
Sarah Fiske
[1.1.10.4.9.2.1]
b. Abt 1646 d. 8 May 1647
7
Elizabeth Fiske
[1.1.10.4.9.2.2]
b. Abt 1649 d. 25 Mar 1730
John Russell
b. 11 Sep 1645 d. 25 Mar 1737
8
John Russell
[1.1.10.4.9.2.2.1]
b. 9 Nov 1671 d. 14 Jun 1746
Rebecca Blodgett
b. 5 Jun 1689 d. 25 Jan 1768
9
Rebekah Russell
[1.1.10.4.9.2.2.1.1]
b. 24 Jun 1711
9
Adonijah Russell
[1.1.10.4.9.2.2.1.2]
b. 25 Feb 1713 d. 21 Feb 1775
Mary Sherman
b. 24 Jul 1713 d. 20 Oct 1782
10
Mary Russell
[1.1.10.4.9.2.2.1.2.1]
b. 27 Oct 1732
10
Adonijah Russell
[1.1.10.4.9.2.2.1.2.2]
b. 14 Sep 1734 d. 15 May 1778
10
Abigail Russell
[1.1.10.4.9.2.2.1.2.3]
b. 25 Nov 1736
10
Rebecca Russell
[1.1.10.4.9.2.2.1.2.4]
b. 23 Dec 1738
10
Ruth Russell
[1.1.10.4.9.2.2.1.2.5]
b. 16 Apr 1741 d. Aft 1778
10
Daniel Russell
[1.1.10.4.9.2.2.1.2.6]
b. 28 Jul 1743
10
Priscilla Russell
[1.1.10.4.9.2.2.1.2.7]
b. 2 Apr 1746
10
Solomon Russell
[1.1.10.4.9.2.2.1.2.8]
b. 3 Oct 1748
10
Phebe Russell
[1.1.10.4.9.2.2.1.2.9]
b. 8 Jun 1752
10
Joseph Russell
[1.1.10.4.9.2.2.1.2.10]
b. 2 Jul 1758
9
Abigail Russell
[1.1.10.4.9.2.2.1.3]
b. 15 Feb 1716
9
John Russell
[1.1.10.4.9.2.2.1.4]
b. 26 Apr 1719
9
Solomon Russell
[1.1.10.4.9.2.2.1.5]
b. 11 Aug 1723
9
Joseph Russell
[1.1.10.4.9.2.2.1.6]
b. 24 Aug 1729 d. 1755
8
David Russell
[1.1.10.4.9.2.2.2]
b. 13 Sep 1673 d. 29 Oct 1744
+
Abigail Winter
b. 12 Mar 1680 d. 2 Dec 1740
8
Martha Russell
[1.1.10.4.9.2.2.3]
b. 13 Aug 1675 d. 7 Nov 1675
8
Benjamin Russell
[1.1.10.4.9.2.2.4]
b. 2 Apr 1677 d. 19 Apr 1677
8
Abigail Russell
[1.1.10.4.9.2.2.5]
b. 18 Apr 1686
8
Patience Russell
[1.1.10.4.9.2.2.6]
b. 27 May 1688 d. 27 May 1688
7
Seaborn Fiske
[1.1.10.4.9.2.3]
b. 6 Sep 1655 d. Abt 1657
7
Hannah Fiske
[1.1.10.4.9.2.4]
b. 27 Mar 1659 d. 27 Jan 1726
7
Abigail Fiske
[1.1.10.4.9.2.5]
b. 1 Feb 1664 d. 7 Jan 1771
Henry Baldwin
b. 15 Nov 1664 d. 7 Jul 1739
8
Henry Baldwin
[1.1.10.4.9.2.5.1]
b. 12 Jan 1693 d. 7 Jul 1753
8
Deacon Isaac Baldwin
[1.1.10.4.9.2.5.2]
b. 20 Feb 1700 d. 8 Mar 1759
8
William Baldwin
[1.1.10.4.9.2.5.3]
b. 20 Feb 1700
8
David Baldwin
[1.1.10.4.9.2.5.4]
b. 9 Apr 1696 d. 7 Mar 1784
8
Jane Baldwin
[1.1.10.4.9.2.5.5]
b. 11 Jul 1703
8
Abigail Baldwin
[1.1.10.4.9.2.5.6]
b. 19 Nov 1707 d. 1751
8
James Baldwin
[1.1.10.4.9.2.5.7]
b. 19 Oct 1710 d. 28 Jan 1791
6
Marie Fiske
[1.1.10.4.9.3]
c. 28 Feb 1625
6
Nathan Fiske
[1.1.10.4.9.4]
b. Abt 1626
6
Martha Fiske
[1.1.10.4.9.5]
b. Abt 1628 d. 1678
Thomas Fitche
c. 26 Oct 1628 d. 1678
7
Martha Fitche
[1.1.10.4.9.5.1]
b. 9 Nov 1650
7
Mary Fitche
[1.1.10.4.9.5.2]
b. 17 Feb 1658
7
Elisabeth Fitche
[1.1.10.4.9.5.3]
b. 1659 d. Bef 2 Aug 1664
7
Thomas Fitche
[1.1.10.4.9.5.4]
b. 1660 d. 23 Jun 1736
7
Sarah Fitche
[1.1.10.4.9.5.5]
b. 14 Jun 1661
7
Elizabeth Fitche
[1.1.10.4.9.5.6]
b. 1664 d. 20 Apr 1731
Edward Taylor
b. 8 Jan 1662 d. 2 Dec 1719
8
Isabella Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.1]
c. 3 Jul 1690 bur. 23 Jan 1705
8
George Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2]
b. 9 Apr 1693 d. 9 Apr 1771
Ann Moon
b. 11 Mar 1693 bur. 5 Apr 1763
9
Elizabeth Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.1]
c. 28 Feb 1720 bur. 9 Mar 1793
9
Ann Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.2]
c. 11 Mar 1721 bur. 19 Jan 1789
9
Edward Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.3]
c. 3 Jan 1724 bur. 30 Jul 1725
9
Agnes Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.4]
c. 9 Jan 1726 bur. 4 Apr 1801
9
Daughter Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.5]
b. Abt 1728 bur. 24 May 1730
9
William Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.6]
b. Abt 1729 bur. 8 Feb 1730
9
George Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.7]
b. 20 Apr 1730 bur. 18 May 1732
9
Edward Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.8]
b. 10 Sep 1733 d. 29 Dec 1782
Elizabeth Saul
b. 21 Jul 1740 d. 30 Nov 1801
10
Mary Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.8.1]
b. 16 Jul 1779 d. 1 Feb 1856
10
Jane Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.8.2]
b. 25 Dec 1780
10
Agnes Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.8.3]
b. 21 Jun 1782 d. 20 Jun 1858
10
James Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.8.4]
c. 20 Jul 1783 d. 27 May 1870
Agnes Taylor
b. 22 Aug 1787 d. 15 Nov 1868
11
Edward Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.8.4.1]
b. 12 Jan 1807 d. 1828
11
John Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.8.4.2]
b. 1 Nov 1808 d. 25 Jul 1887
Leonora Cannon
b. 5 Oct 1796 d. 9 Dec 1868
12
George John Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.8.4.2.1]
b. 31 Jan 1834 d. 15 Dec 1914
12
Mary Ann Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.8.4.2.2]
b. 23 Jan 1836 d. 1890
12
Joseph James Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.8.4.2.3]
b. 8 Jun 1838 d. 31 Jan 1908
12
Lenora Agnes Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.8.4.2.4]
b. 1 Jun 1840 d. 9 Sep 1843
Elizabeth Kaighin
b. 11 Sep 1811 d. 31 Aug 1895
12
Josephine K Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.8.4.2.5]
b. 1846 d. 1921
12
Thomas Edward Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.8.4.2.6]
b. 7 Nov 1849 d. 11 Dec 1915 [
=>
]
12
Arthur Bruce Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.8.4.2.7]
b. 9 Oct 1853 d. 24 Mar 1934
Jane Ballantyne
b. 11 Apr 1813 d. 26 Dec 1900
12
Richard James Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.8.4.2.8]
b. 4 Feb 1848 d. 17 Mar 1905
12
Annie Maria Ballantyne Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.8.4.2.9]
b. 21 Oct 1849 d. 12 Mar 1909
12
David John Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.8.4.2.10]
b. 8 Aug 1853 d. 6 Sep 1881
Mary Ann Oakley
b. 20 Mar 1826 d. 21 Aug 1911
12
Henry Edgar Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.8.4.2.11]
b. 26 Dec 1849 d. 22 Jun 1928
12
Mary Elizabeth Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.8.4.2.12]
b. 30 Jan 1854 d. 16 Jan 1859
12
Brigham John Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.8.4.2.13]
b. 8 Aug 1858 d. 20 Jan 1929
12
Ida Oakley Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.8.4.2.14]
b. 6 Sep 1860 d. 23 May 1946
12
Ezra Oakley Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.8.4.2.15]
b. 20 May 1863 d. 19 Jul 1952 [
=>
]
+
Mercy Rachel Fielding
b. 15 Jun 1807 d. 15 Sep 1893
Sophia Whitaker
b. 21 Apr 1825 d. 28 Feb 1887
12
Harriet Ann Whitaker Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.8.4.2.16]
b. 7 Dec 1847 d. 16 Oct 1908
12
James Whittaker Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.8.4.2.17]
b. 2 Mar 1850 d. 25 Mar 1851
12
Hyrum Whittaker Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.8.4.2.18]
b. 10 Jan 1854 d. 22 Mar 1942
12
John Whittaker Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.8.4.2.19]
b. 15 May 1858 d. 10 Oct 1916
12
Helena Whittaker Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.8.4.2.20]
b. 21 Mar 1860 d. 1870
12
Moses Whitaker Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.8.4.2.21]
b. 9 Mar 1862 d. 13 Jan 1922
12
Nettie Jones
[1.1.10.4.9.5.6.2.8.4.2.22]
b. 12 Jun 1864 d. 17 May 1943
12
Frederick Whitaker Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.8.4.2.23]
b. 18 Jul 1866 d. 11 Jan 1952
Harriet Whitaker
b. 30 Jul 1816 d. 16 Jul 1862
12
Sophia Elizabeth Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.8.4.2.24]
b. 14 Jun 1849 d. 20 Mar 1909
12
William Whitaker Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.8.4.2.25]
b. 11 Sep 1853 d. 1 Aug 1884
12
John Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.8.4.2.26]
b. 19 Mar 1855 d. 29 Mar 1855
+
Caroline Hooper Saunders
b. 3 Jan 1813 d. 7 Feb 1874
Margaret Young
b. 24 Apr 1837 d. 3 May 1919
12
Ebenezer Young Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.8.4.2.27]
b. 25 Feb 1860 d. 28 Jan 1939
12
Frank Young Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.8.4.2.28]
b. 4 Nov 1861 d. 19 Mar 1953
12
Leonora Young Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.8.4.2.29]
b. 25 Mar 1864 d. 26 Jul 1935
12
Robert Young Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.8.4.2.30]
b. 2 Mar 1866 d. 30 Sep 1867
12
Margaret Young Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.8.4.2.31]
b. 15 Mar 1870 d. 16 Sep 1935
12
Nephi Young Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.8.4.2.32]
b. 25 Oct 1872 d. 27 Mar 1948
12
Mary Young Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.8.4.2.33]
b. 6 Dec 1874 d. 7 Apr 1898
12
Abraham Young Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.8.4.2.34]
b. 12 Dec 1878 d. 17 May 1945
12
Samuel Young Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.8.4.2.35]
b. 20 Nov 1881 d. 22 Jul 1952
+
Josephine Elizabeth Roueche
b. 3 Mar 1860 d. 27 Nov 1943
11
James Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.8.4.3]
b. 1810 d. 24 Jan 1878
11
George Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.8.4.4]
b. 1814 bur. 1814
11
Elizabeth Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.8.4.5]
b. 4 Sep 1819 d. 31 Jul 1909
11
Agnes Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.8.4.6]
b. 2 Oct 1821 d. 12 Dec 1911
Wilhem Schwarz
b. 23 Jun 1837 d. 15 Aug 1915
12
Harriet Taylor Schwartz
[1.1.10.4.9.5.6.2.8.4.6.1]
b. 1862 d. 1862
12
Mary Taylor Schwartz
[1.1.10.4.9.5.6.2.8.4.6.2]
b. 30 Apr 1865 d. 5 Dec 1956 [
=>
]
11
William B Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.8.4.7]
b. 2 Sep 1823 d. 10 May 1910
11
George Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.8.4.8]
b. 9 Jan 1826 d. 1836
11
Edward Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.2.8.4.9]
b. 12 Feb 1830 d. 1836
8
Ellen Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.3]
b. 1696 bur. Mar 1685
8
Agnes Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.4]
b. Abt 1698 bur. 20 Feb 1725
8
Elizabeth Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.5]
c. 11 Aug 1700 bur. 30 Sep 1728
8
Margaret Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.6]
b. 9 Jun 1703
8
Edward Taylor
[1.1.10.4.9.5.6.7]
c. Abt 23 May 1691
5
Elizabeth Fiske
[1.1.10.4.10]
b. 22 Apr 1599
+
Pygott
b. Abt 1595
5
Martha Fiske
[1.1.10.4.11]
b. 9 Sep 1602 d. 6 May 1684
Martin Underwood
b. 1595 d. 17 Nov 1672
6
Thomas Underwood
[1.1.10.4.11.1]
b. Abt 1614 d. 16 Feb 1691
6
Joseph Underwood
[1.1.10.4.11.2]
c. 28 Feb 1614 d. 16 Dec 1676
5
Elizabeth Fiske
[1.1.10.4.12]
b. Abt 1612
2
James Gould
[1.2]
b. Abt 1474 d. Bef 16 Mar 1530
2
John Gould
[1.3]
b. Abt 1476 d. 1534
Katherine Preston
b. Abt 1480 d. Aft 21 Feb 1529
3
Richard Gould
[1.3.1]
b. Abt 1507 d. Bef 28 Oct 1557
3
Robert Gould
[1.3.2]
b. Abt 1509 d. Bef 14 Jun 1559
3
Thomas Gould
[1.3.3]
b. Abt 1511 d. 6 Jul 1571
Joan Ball
b. Abt 1516 d. 4 Mar 1602
4
Amye Gould
[1.3.3.1]
b. 15 Jan 1532 d. 1578
William Thomas Dimery
b. Abt 1530 d. 1578
5
Ursula Alice Dimery
[1.3.3.1.1]
b. 1562 d. 13 Dec 1619
Richard Thayer
b. 2 Aug 1562 d. 1625
6
Joanne Thayer
[1.3.3.1.1.1]
b. 1592 d. 5 Feb 1592
6
Mary Thayer
[1.3.3.1.1.2]
b. 1 Mar 1595 d. 1636
William Jeggles
b. Abt 1590 d. May 1659
7
Mary Jeggles
[1.3.3.1.1.2.1]
b. Abt 1614
7
David Jeggles
[1.3.3.1.1.2.2]
b. 1617
7
Bridget Jeggles
[1.3.3.1.1.2.3]
b. 10 Jun 1619 d. 2 May 1680
John Rowe
b. 13 Oct 1607 d. 9 Mar 1662
8
John Rowe
[1.3.3.1.1.2.3.1]
b. Abt 1643 d. 25 Sep 1700
8
Hugh Rowe
[1.3.3.1.1.2.3.2]
b. Abt 1645 d. 11 Dec 1696
Rachel Langton
b. Abt 1650 d. 7 Mar 1674
9
Rachael Rowe
[1.3.3.1.1.2.3.2.1]
b. 10 Nov 1668 d. 6 Sep 1698
9
Ruth Rowe
[1.3.3.1.1.2.3.2.2]
b. 26 Jun 1671 d. 10 May 1736
Nathaniel Day
b. 9 Sep 1665 d. 25 Feb 1734
10
Benjamin Day
[1.3.3.1.1.2.3.2.2.1]
b. 19 Sep 1691 d. 6 Aug 1776
10
Ruth Day
[1.3.3.1.1.2.3.2.2.2]
b. 17 Jan 1694/1695 d. 4 Jan 1781
10
Nathaniel Day
[1.3.3.1.1.2.3.2.2.3]
b. 30 Mar 1696 d. 16 Dec 1699
10
Rachel Day
[1.3.3.1.1.2.3.2.2.4]
b. 7 Jul 1698 d. 19 Sep 1723
10
Nathaniel Day
[1.3.3.1.1.2.3.2.2.5]
b. 10 Sep 1700
10
David Day
[1.3.3.1.1.2.3.2.2.6]
b. 29 Jan 1702 d. 19 Jan 1768
Ruth Whipple
b. 8 Jun 1705 d. 1789
11
David Day
[1.3.3.1.1.2.3.2.2.6.1]
b. 19 Oct 1728 d. 31 Aug 1749
11
Lydia Day
[1.3.3.1.1.2.3.2.2.6.2]
b. 5 Dec 1730 d. 8 May 1804
11
Elkniah Day
[1.3.3.1.1.2.3.2.2.6.3]
b. 19 Jan 1732
11
Dorcas Day
[1.3.3.1.1.2.3.2.2.6.4]
b. 23 May 1735 d. 7 Dec 1739
11
Ruth Day
[1.3.3.1.1.2.3.2.2.6.5]
b. 6 Aug 1737 d. 1837
11
Comfort Day
[1.3.3.1.1.2.3.2.2.6.6]
b. 13 Mar 1741 d. 1799
11
Eliphalet Day
[1.3.3.1.1.2.3.2.2.6.7]
b. 2 Mar 1744 d. 19 Feb 1820
11
Dorcas Day
[1.3.3.1.1.2.3.2.2.6.8]
b. 13 Jan 1746
11
Laommi Day
[1.3.3.1.1.2.3.2.2.6.9]
b. 13 Aug 1750 d. 30 Nov 1827
10
Mary Day
[1.3.3.1.1.2.3.2.2.7]
b. 16 May 1707
10
Miriam Day
[1.3.3.1.1.2.3.2.2.8]
b. 1 Oct 1709 d. 16 Dec 1799
10
Deborah Day
[1.3.3.1.1.2.3.2.2.9]
b. 31 Mar 1712 d. 10 Sep 1730
10
Dorcas Day
[1.3.3.1.1.2.3.2.2.10]
b. Abt 1714 d. 16 Mar 1759
John Fillmore
b. 18 Mar 1702 d. 22 Feb 1777
11
Jemima Fillmore
[1.3.3.1.1.2.3.2.2.10.1]
b. 1 Apr 1737 d. 1 Dec 1741
11
Miriam Fillmore
[1.3.3.1.1.2.3.2.2.10.2]
b. 1738 d. Abt 1807
11
Nathaniel Fillmore
[1.3.3.1.1.2.3.2.2.10.3]
b. 20 Mar 1740 d. 7 Sep 1814
Hepzibah Wood
b. 14 Apr 1747 d. 11 May 1783
12
Simeon Fillmore
[1.3.3.1.1.2.3.2.2.10.3.1]
b. 13 Dec 1768 d. 30 Apr 1848
12
Nathaniel Fillmore, Jr
[1.3.3.1.1.2.3.2.2.10.3.2]
b. 19 Apr 1771 d. 28 Mar 1863 [
=>
]
12
Philippa Fillmore
[1.3.3.1.1.2.3.2.2.10.3.3]
b. 22 Mar 1773 d. 2 Apr 1867
12
Calvin Fillmore
[1.3.3.1.1.2.3.2.2.10.3.4]
b. 30 Apr 1775 d. 22 Oct 1865
12
Elijah Day Fillmore
[1.3.3.1.1.2.3.2.2.10.3.5]
b. 8 Apr 1778 d. 11 Jul 1856
12
Devias Fillmore
[1.3.3.1.1.2.3.2.2.10.3.6]
b. 28 Sep 1781 d. 15 Jun 1864
11
Comfort Fillmore
[1.3.3.1.1.2.3.2.2.10.4]
b. 25 Jan 1742 d. 24 Jan 1814
11
Benjamin Fillmore
[1.3.3.1.1.2.3.2.2.10.5]
b. 28 Jan 1744
11
Mimee Fillmore
[1.3.3.1.1.2.3.2.2.10.6]
b. 3 Jan 1745 d. Aft 1790
11
Calvin Fillmore
[1.3.3.1.1.2.3.2.2.10.7]
b. 24 Feb 1752 d. 1753
11
Ebenezer Fillmore
[1.3.3.1.1.2.3.2.2.10.8]
b. Abt 1759
11
Luther Fillmore
[1.3.3.1.1.2.3.2.2.10.9]
b. 14 Jan 1759 d. 9 Feb 1809
9
Mary Rowe
[1.3.3.1.1.2.3.2.3]
b. 5 Feb 1673 d. 1741
Mary Prince
b. 19 Jul 1658 d. 3 Mar 1723
9
Margaret Rowe
[1.3.3.1.1.2.3.2.4]
b. 25 Sep 1675 d. 2 Dec 1675
9
Abigail Rowe
[1.3.3.1.1.2.3.2.5]
b. 19 Dec 1677 d. 8 Jul 1706
9
Abraham Rowe
[1.3.3.1.1.2.3.2.6]
b. 26 Apr 1680 d. 8 Jul 1706
9
Isaac Rowe
[1.3.3.1.1.2.3.2.7]
b. 13 Oct 1682 d. 23 Jul 1723
9
Jacob Rowe
[1.3.3.1.1.2.3.2.8]
b. 17 Jun 1685 d. 1730
9
Benjamin Rowe
[1.3.3.1.1.2.3.2.9]
b. 9 Nov 1690 d. 1744
9
Job Rowe
[1.3.3.1.1.2.3.2.10]
b. Abt 1692
9
Martha Rowe
[1.3.3.1.1.2.3.2.11]
b. 1694
9
Mary Rowe
[1.3.3.1.1.2.3.2.12]
b. 1696 d. 7 May 1774
7
Elizabeth Jeggles
[1.3.3.1.1.2.4]
b. Abt 1623 d. 3 Sep 1644
7
Hugh Jeggles
[1.3.3.1.1.2.5]
b. Abt 1625 d. 3 Sep 1644
7
Thomas Jeggles
[1.3.3.1.1.2.6]
b. Abt 1628 d. 1686
7
Abigail Jeggles
[1.3.3.1.1.2.7]
b. Abt 1630
6
Thomas Thayer
[1.3.3.1.1.3]
b. 16 Aug 1596 d. 2 Jun 1665
Margery Wheeler
b. 25 Apr 1600 d. 11 Feb 1672
7
Margery Thayer
[1.3.3.1.1.3.1]
b. Abt 1620 d. 8 Jul 1676
7
Welfrey Thayer
[1.3.3.1.1.3.2]
b. 20 May 1621 d. 10 Jul 1621
7
Thomas Thayer
[1.3.3.1.1.3.3]
b. 15 Sep 1622 d. 9 May 1693
+
Anna Carle
b. Abt 1625 d. 7 Feb 1699
7
Ferdinando Thayer
[1.3.3.1.1.3.4]
b. 18 Apr 1625 d. 28 Mar 1713
Huldah Hayward
c. 14 Oct 1636 d. 1 Sep 1690
8
Sarah Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.1]
b. 12 Mar 1654 d. 16 Oct 1677
Jonathan Hayward
b. 1641 d. 21 Nov 1690
9
Hannah Hayward
[1.3.3.1.1.3.4.1.1]
b. 22 Jan 1664 d. 7 Dec 1747
9
Sarah Hayward
[1.3.3.1.1.3.4.1.2]
b. 10 Jan 1665 d. 30 May 1676
9
Jonathan Hayward
[1.3.3.1.1.3.4.1.3]
b. 18 Nov 1667 d. 13 Jul 1757
9
William Hayward
[1.3.3.1.1.3.4.1.4]
b. 6 Feb 1668 d. 26 Mar 1697
9
Huldah Hayward
[1.3.3.1.1.3.4.1.5]
b. 28 Mar 1672
9
Samuel Hayward
[1.3.3.1.1.3.4.1.6]
b. 2 Jan 1675 d. 4 Aug 1676
9
Sarah Hayward
[1.3.3.1.1.3.4.1.7]
b. 12 Dec 1679 d. 13 Dec 1711
9
Samuel Hayward
[1.3.3.1.1.3.4.1.8]
b. 11 Apr 1682 d. 29 Dec 1745
8
Huldah Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.2]
b. 16 Jun 1657 d. 1699
Jacob Aldrich
b. 28 Feb 1652 d. 22 Oct 1695
9
Jacob Aldrich
[1.3.3.1.1.3.4.2.1]
b. 7 May 1676 d. 23 Aug 1753
Margery Hayward
b. Abt 1675
10
Mercy Aldrich
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1]
b. 21 Jun 1700 d. Aft 19 Sep 1753
Israel Taft
b. 26 Apr 1699 d. 19 Sep 1753
11
Huldah Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.1]
b. 28 Jun 1718 d. 2 Jul 1799
David Daniels
b. 4 Jul 1710 d. 21 May 1776
12
Ruth Daniels
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.1.1]
b. 13 Jul 1738 d. 26 Sep 1798 [
=>
]
12
Daniel Daniels
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.1.2]
b. 4 Nov 1740 d. 24 May 1832 [
=>
]
12
Molly Daniels
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.1.3]
b. 1 Oct 1741 d. 13 Apr 1793 [
=>
]
12
Azor Daniels
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.1.4]
b. 20 Feb 1743 d. 19 Sep 1748
12
Chloe Daniels
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.1.5]
b. 13 Sep 1745 d. 19 May 1823 [
=>
]
12
Matilda Daniels
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.1.6]
b. 16 Sep 1747 [
=>
]
12
David Daniels
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.1.7]
b. 10 Nov 1749 d. 30 Apr 1811
12
Huldah Daniels
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.1.8]
b. 6 Jan 1752 d. 26 Jun 1836 [
=>
]
12
Moses Daniels
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.1.9]
b. 25 Feb 1753 [
=>
]
12
Clotilda Daniels
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.1.10]
b. 19 Sep 1755 d. Abt 1813 [
=>
]
11
Priscilla Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.2]
b. 15 Aug 1721 d. Jan 1760
Moses Wood
b. 3 Apr 1712 d. Apr 1780
12
Mary Wood
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.2.1]
b. 3 Mar 1740 d. 17 Apr 1841
12
Prissella Wood
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.2.2]
b. 18 May 1741 d. 18 May 1741
12
Jerusha Wood
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.2.3]
b. Abt 1744 d. 27 Apr 1790
12
Rachel Wood
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.2.4]
b. 9 Jun 1746
12
Moses Wood
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.2.5]
b. Abt 1748
12
Susanna Wood
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.2.6]
b. Abt 1748
12
Daniel Wood
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.2.7]
b. 10 Mar 1757
12
Hezekiah Wood
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.2.8]
b. 14 Jan 1760 d. 26 May 1811
12
Rhoda Wood
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.2.9]
b. 13 Apr 1762
11
Israel Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.3]
b. 23 Apr 1723 d. 1775
Martha Smith
b. 1722
12
Israel Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.3.1]
b. 12 Dec 1743
12
Amariah Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.3.2]
b. 18 Apr 1746 d. 1770
12
Oliver Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.3.3]
b. 4 Feb 1750
12
Elizabeth Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.3.4]
b. 27 Jul 1753
12
Marce Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.3.5]
b. 16 Jan 1757
11
Jacob Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.4]
b. 22 Apr 1725 d. 15 Mar 1802
Esther Marsh
b. 28 Jun 1726 d. 14 Mar 1802
12
Esther Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.4.1]
b. 9 Jan 1747 d. 3 Feb 1834 [
=>
]
12
Timothy Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.4.2]
b. 3 Apr 1750 d. 30 Nov 1808 [
=>
]
12
Jacob Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.4.3]
b. 1 Dec 1751 d. 30 May 1823 [
=>
]
12
Abigail Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.4.4]
b. 5 Oct 1754 d. 12 Aug 1775 [
=>
]
12
Lois Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.4.5]
b. 28 Apr 1757 d. 10 Feb 1792 [
=>
]
12
Mercy Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.4.6]
b. 5 Mar 1758 d. 18 Feb 1843 [
=>
]
12
Israel Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.4.7]
b. 1 Mar 1761 d. 24 Apr 1842 [
=>
]
12
Eastman Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.4.8]
b. 16 Jun 1763 d. 29 Apr 1829 [
=>
]
11
Hannah Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.5]
b. 16 Nov 1726 d. 15 Mar 1802
Elijah Clarke Benjamin
b. 8 Jun 1725 d. 1768
12
Elias Benjamin
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.5.1]
b. 4 May 1750 d. 8 Apr 1823 [
=>
]
12
Chester Benjamin
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.5.2]
b. 9 Feb 1751 d. 1830
12
William Benjamin
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.5.3]
b. 6 Mar 1753
12
Captain Elijah Taft Benjamin
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.5.4]
b. 27 Dec 1755 d. 17 Jun 1819 [
=>
]
12
Cyrus Benjamin
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.5.5]
b. 7 Jul 1762 d. 19 Jul 1817 [
=>
]
12
Hannah Benjamin
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.5.6]
b. 7 Jul 1762 d. 13 May 1840
12
Mary Benjamin
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.5.7]
b. 7 Jul 1768 d. 5 Feb 1849
12
Darius Benjamin
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.5.8]
b. 17 Jan 1758 d. 12 Feb 1850
11
Elisha Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.6]
b. 3 May 1728 d. 3 Mar 1791
Experience Taft
b. 7 Apr 1733 d. 15 Mar 1817
12
Hannah Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.6.1]
b. 16 Mar 1758
12
Elisha Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.6.2]
b. 4 Mar 1761 d. 16 Jan 1820 [
=>
]
12
Sarah Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.6.3]
b. 21 Mar 1763 d. 11 Oct 1835 [
=>
]
12
Israel Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.6.4]
b. 12 Feb 1766
12
Joseph Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.6.5]
b. 15 Sep 1768 d. Aft 29 Sep 1815 [
=>
]
11
Mercy Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.7]
b. 7 Apr 1733 d. 27 Mar 1801
Benjamin Green
b. 11 Aug 1734 d. 16 Aug 1797
12
Benjamin Green
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.7.1]
b. 6 Jan 1754
12
Israel Green
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.7.2]
b. 22 Jun 1755
12
Margery Green
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.7.3]
b. 1 Feb 1758 d. 22 Sep 1838 [
=>
]
12
Marcy Green
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.7.4]
b. 1 Jan 1760 d. 8 Jun 1815 [
=>
]
12
Hannah Green
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.7.5]
b. 2 Apr 1763
12
Rachel Green
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.7.6]
b. 27 Aug 1765
12
Samuel Green
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.7.7]
b. 14 Mar 1767
11
Stephen Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.8]
b. 21 Aug 1734 d. 3 Feb 1803
Anna Taft
b. 14 Apr 1748 d. 3 Apr 1830
12
Lydia Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.8.1]
b. 13 Oct 1766 d. 13 Jan 1847
12
Hazeltine Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.8.2]
b. 6 Jan 1769 d. 18 Jul 1856
12
Gravenor Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.8.3]
b. 1773 d. 1838
12
Marcy Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.8.4]
b. 5 Sep 1775
12
Ephraim Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.8.5]
b. 18 Aug 1780 [
=>
]
12
Lovice Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.8.6]
b. 1 Jul 1783
12
Anna Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.8.7]
b. 29 Nov 1784
12
Stephen Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.8.8]
b. 12 Dec 1787
12
Adolphas Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.8.9]
b. 2 Oct 1791
11
Samuel Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.9]
b. 23 Sep 1735 d. 2 Aug 1816
Mary Murdock
b. 3 Jan 1742 d. 26 Mar 1785
12
Frederick Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.9.1]
b. 19 Jun 1759 d. 10 Feb 1846 [
=>
]
12
Sibbel Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.9.2]
b. 19 Aug 1760 d. 28 Sep 1761
12
Lyman Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.9.3]
b. 14 Mar 1762 d. 24 Jul 1833
12
Mercy Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.9.4]
b. 23 Apr 1765 d. 25 Apr 1768
12
Willard Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.9.5]
b. 30 Oct 1766 d. 14 Sep 1845
12
Parley Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.9.6]
b. 20 Jan 1768 d. 13 Apr 1768
12
Merret Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.9.7]
b. 26 Jan 1769
12
Otis Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.9.8]
b. 29 Oct 1771
12
Farla Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.9.9]
b. 24 Mar 1774 d. 6 Apr 1864
12
Washington Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.9.10]
b. 16 Sep 1775
12
Philena Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.9.11]
b. 11 Mar 1781 d. 1814
12
George Washington Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.9.12]
b. 1 May 1783 d. 30 Nov 1824
Experiance Humes
b. 27 May 1750 d. 15 Jan 1837
12
Dandridge Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.9.13]
b. 1 Aug 1787 d. 10 Aug 1832
12
Warner Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.9.14]
b. 15 Sep 1789 d. 3 Aug 1837
12
Experiance Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.9.15]
b. 10 Jun 1791 d. 30 Nov 1863
12
Polley Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.9.16]
b. 18 Mar 1794
11
Margery Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.10]
b. 14 May 1738 d. 20 Jan 1813
Simeon Wood
b. 7 Jan 1732 d. 11 May 1802
12
Stephen Wood
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.10.1]
b. 14 Oct 1761 d. Abt 1820
12
Simeon Wood, Jr
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.10.2]
b. 14 Oct 1761 d. 1819
12
Rhoda Wood
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.10.3]
b. 25 May 1763 d. 8 Apr 1832
12
Jerusha Wood
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.10.4]
b. 28 Jun 1765 d. 8 Apr 1832 [
=>
]
12
Caleb Wood
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.10.5]
b. 2 Jun 1767 d. 24 Jun 1769
12
Willis Wood
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.10.6]
b. 14 Jul 1769 d. 5 Oct 1779
12
Nathaniel G Wood
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.10.7]
b. 24 Jul 1771 d. 4 Sep 1847
12
Lois Wood
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.10.8]
b. 8 Nov 1772 d. 20 Apr 1773
12
Eunice Wood
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.10.9]
b. 11 Apr 1773 d. 28 Jun 1791
12
Jesse Wood
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.10.10]
b. 29 Aug 1775 d. Bef 1884
12
Mary Wood
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.10.11]
b. 3 Jan 1778 d. 3 Jan 1868
12
Sibel Wood
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.10.12]
b. 12 Jan 1781 d. Feb 1831
11
Silas Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.11]
b. 17 Dec 1739 d. 10 May 1741
11
Rachel Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.12]
b. 18 Jul 1742 d. 30 Dec 1747
11
Silas Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.13]
b. 5 Nov 1744
Elizabeth Sadler
b. 13 Sep 1754
12
Stephen Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.13.1]
b. 22 Feb 1773 d. 26 Oct 1846
12
Silas Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.13.2]
b. 2 Jun 1775
12
Israel Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.13.3]
b. 22 Sep 1777 d. 19 May 1842
12
Joel Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.13.4]
b. 28 Apr 1780
12
Belzaleel Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.13.5]
b. 28 Jan 1783 d. 15 Apr 1831
12
Otis Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.13.6]
b. 17 Sep 1786 d. 19 Nov 1827 [
=>
]
12
Samuel Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.13.7]
b. 18 Oct 1788 d. 20 Oct 1859
12
Elisha Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.13.8]
b. 15 Feb 1791 d. 26 Dec 1849
12
Elizabeth Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.13.9]
b. 2 Feb 1795
11
Phila Taft
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.1.14]
b. Abt 1748 d. 1794
10
Jacob Aldrich
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.2]
b. 1 Oct 1701 d. 30 Oct 1701
10
Huldah Aldrich
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.3]
b. 29 Jan 1703 d. 1748
10
Hannah Aldrich
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.4]
b. 3 Jun 1704 d. 18 Mar 1794
10
Experience Aldrich
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.5]
b. 30 Dec 1708 d. Abt 1751
10
Jacob Aldrich
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.6]
b. 29 May 1711
10
Bethiah Aldrich
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.7]
b. 7 Mar 1713
10
Margaret Aldrich
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.8]
b. 14 Mar 1714 d. 7 Oct 1767
10
Noah Aldrich
[1.3.3.1.1.3.4.2.1.9]
b. 28 Aug 1717 d. 1759
9
Abel Aldrich
[1.3.3.1.1.3.4.2.2]
b. 27 Jan 1678
9
Seth Aldrich
[1.3.3.1.1.3.4.2.3]
b. 6 Jul 1679 d. 15 Oct 1737
+
Deborah Hayward
b. 9 Nov 1682
9
Huldah Aldrich
[1.3.3.1.1.3.4.2.4]
b. 6 Nov 1680
9
Sarah Aldrich
[1.3.3.1.1.3.4.2.5]
b. 24 Oct 1683
9
David Aldrich
[1.3.3.1.1.3.4.2.6]
b. 23 May 1685 d. 15 Mar 1771
9
Peter Aldrich
[1.3.3.1.1.3.4.2.7]
b. 19 Oct 1686 d. 1724
+
Experience Cook
b. 9 Nov 1662 bur. 1770
+
Hannah Hayward
b. 18 Aug 1680 d. 1746
9
John Aldrich
[1.3.3.1.1.3.4.2.8]
b. 27 Nov 1688 d. 25 Mar 1750
9
Moses Aldrich
[1.3.3.1.1.3.4.2.9]
b. 1 Apr 1690 d. 9 Sep 1761
9
Mercy Aldrich
[1.3.3.1.1.3.4.2.10]
b. 17 Feb 1692 d. 18 Mar 1693
9
Rachel Aldrich
[1.3.3.1.1.3.4.2.11]
b. 27 Dec 1694
8
Jonathan Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.3]
b. 18 Jan 1658 d. 1690
Elisabeth French
b. 1640 bur. 3 Oct 1703
9
Huldah Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.3.1]
b. 11 Mar 1682 d. 7 Jul 1739
Benjamin Wheelock
b. 12 Dec 1678 d. 13 Sep 1746
10
Benjamin Wheelock
[1.3.3.1.1.3.4.3.1.1]
b. 10 Apr 1704 d. 1777
Deborah Taft
b. 14 Nov 1702 d. 9 Aug 1747
11
Benjamin Wheelock
[1.3.3.1.1.3.4.3.1.1.1]
b. 17 Aug 1729 d. 16 Apr 1776
11
Jesse Wheelock
[1.3.3.1.1.3.4.3.1.1.2]
b. 8 Sep 1731 d. Bef 4 Sep 1781
Phoebe White
b. 8 Oct 1737 d. Mar 1783
12
Phineas Wheelock
[1.3.3.1.1.3.4.3.1.1.2.1]
b. 28 Apr 1754 d. 21 Jun 1759
12
Enock Wheelock
[1.3.3.1.1.3.4.3.1.1.2.2]
b. 14 Oct 1755
12
Mary Wheelock
[1.3.3.1.1.3.4.3.1.1.2.3]
b. 23 May 1756 d. 5 Nov 1807
12
Nathan Wheelock
[1.3.3.1.1.3.4.3.1.1.2.4]
b. 20 Apr 1758
12
Nancy Wheelock
[1.3.3.1.1.3.4.3.1.1.2.5]
b. 14 Nov 1767 d. 9 Oct 1843
12
Abigail Wheelock
[1.3.3.1.1.3.4.3.1.1.2.6]
b. 16 Jan 1772
12
Baruch Wheelock
[1.3.3.1.1.3.4.3.1.1.2.7]
b. 4 Jan 1774 d. 28 Mar 1816
12
Submit Wheelock
[1.3.3.1.1.3.4.3.1.1.2.8]
b. 10 Jan 1782 d. 29 Jan 1823
11
Jonathan Wheelock
[1.3.3.1.1.3.4.3.1.1.3]
b. 8 Sep 1731 d. 1774
Ruth Daniels
b. 13 Jul 1738 d. 26 Sep 1798
12
Eleazer Wheelock
[1.3.3.1.1.3.4.3.1.1.3.1]
b. 15 Jul 1756 d. 1841
12
Dole Wheelock
[1.3.3.1.1.3.4.3.1.1.3.2]
b. 29 May 1758
12
Susannah Wheelock
[1.3.3.1.1.3.4.3.1.1.3.3]
b. 23 Feb 1760 d. 2 May 1776
12
Lyman Wheelock
[1.3.3.1.1.3.4.3.1.1.3.4]
b. 30 Nov 1761 d. 29 Mar 1848
12
Alphaeus Wheelock
[1.3.3.1.1.3.4.3.1.1.3.5]
b. 17 Dec 1763
12
Willard Wheelock
[1.3.3.1.1.3.4.3.1.1.3.6]
b. 19 Jun 1768 d. 29 Mar 1823
12
Deobrah Wheelock
[1.3.3.1.1.3.4.3.1.1.3.7]
b. 17 Dec 1765 d. 3 Aug 1846 [
=>
]
11
Eleazar Wheelock
[1.3.3.1.1.3.4.3.1.1.4]
b. 31 Mar 1734 d. 31 Aug 1747
10
Huldah Wheelock
[1.3.3.1.1.3.4.3.1.2]
b. 17 Aug 1710 d. 1813
10
Jonathan Wheelock
[1.3.3.1.1.3.4.3.1.3]
b. 21 Jul 1713 d. 26 Jul 1783
10
Paul Wheelock
[1.3.3.1.1.3.4.3.1.4]
b. 13 Jan 1715 d. 16 May 1776
10
Silas Wheelock
[1.3.3.1.1.3.4.3.1.5]
b. 11 Mar 1717 d. 22 Apr 1793
10
David Wheelock
[1.3.3.1.1.3.4.3.1.6]
b. 18 Jan 1720 d. 5 Jan 1789
10
Peter Wheelock
[1.3.3.1.1.3.4.3.1.7]
b. 23 Jul 1724 d. 18 Feb 1802
9
Grace Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.3.2]
b. 20 Dec 1684 d. 28 Aug 1720
9
Hezekiah Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.3.3]
b. 8 Feb 1686 d. 13 Jan 1689
9
Deborah Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.3.4]
b. 4 Nov 1687 d. 8 Oct 1733
9
Johnathan Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.3.5]
b. 8 Dec 1690 d. 27 Apr 1747
8
Naomi Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.4]
b. 28 Nov 1662 d. 1718
John Cook
b. 16 Jun 1654 d. 1718
9
John Cook
[1.3.3.1.1.3.4.4.1]
b. 27 Jan 1685
9
Jonathan Cook
[1.3.3.1.1.3.4.4.2]
b. 27 Feb 1685 d. Abt Jan 1759
9
Katharine Cook
[1.3.3.1.1.3.4.4.3]
b. 19 Aug 1687 d. 20 May 1711
9
Naomi Cook
[1.3.3.1.1.3.4.4.4]
b. 13 Mar 1693 d. Bef 14 Jun 1762
Sylvanus Holbrook
b. 15 Aug 1685 d. 1740
10
Ruth Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.1]
b. 13 May 1713
10
Sylvanus Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2]
b. 13 May 1713 d. 1782
Thankful Thayer
b. 4 Aug 1725 d. 10 Dec 1798
11
Sylvanus Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.1]
b. 21 Apr 1750 d. 1828
Mary Thayer
b. 7 Jun 1749 d. 26 May 1831
12
Phebe Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.1.1]
b. 16 Feb 1773 d. 25 Oct 1832
12
Ezekiel Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.1.2]
b. 18 Apr 1777 d. 1799
12
Joseph Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.1.3]
b. 6 Nov 1781
12
Polly Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.1.4]
b. 1783
12
Mary Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.1.5]
b. 16 Oct 1784 d. 15 Aug 1844
11
Ruth Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.2]
b. 10 Aug 1751 d. 16 May 1781
Benoni Benson
b. 11 Jul 1747 d. 1803
12
Amasa Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.2.1]
b. 25 Jan 1771 d. 7 Mar 1837 [
=>
]
12
Chloe Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.2.2]
b. 28 Jan 1774
12
Benoni Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.2.3]
b. 1780 d. 1819
11
Rachel Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.3]
b. 6 Nov 1753 d. 9 Mar 1832
Jonathan Staples
b. 29 Mar 1754 d. 28 Nov 1832
12
Sally Staples
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.3.1]
b. 3 Oct 1779
12
Sylvia Staples
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.3.2]
b. 2 Jan 1781 d. 13 Mar 1852
12
Rachael Staples
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.3.3]
b. Abt 1784 d. 12 Dec 1870
12
Ellery Staples
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.3.4]
b. 1784 d. 1861
12
Willard Staples
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.3.5]
b. 20 Dec 1785 d. 20 Dec 1858
12
Jonathan Staples
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.3.6]
b. 1792
11
Comfort Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.4]
b. 12 Mar 1756
11
Margaret Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.5]
b. 14 Aug 1757 d. Abt 1805
Thadaus Thayer
b. 1 Feb 1754 d. 24 Dec 1826
12
George Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.5.1]
b. 20 Jul 1779 d. 27 May 1836
12
Otis Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.5.2]
b. 17 Mar 1780 d. 13 Apr 1841
12
Arkey Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.5.3]
b. 6 Dec 1781 d. 1783
12
Ellis Holbrook Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.5.4]
b. 9 Mar 1783 d. 2 Jul 1863
12
Ruth Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.5.5]
b. Abt 1784 d. 1821
12
Sylvanus Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.5.6]
b. Abt 1786 d. 7 Mar 1859
12
Margaret Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.5.7]
b. 11 Nov 1787
12
Thaddeus Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.5.8]
b. Nov 1789 d. 4 Mar 1824
12
Margery Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.5.9]
b. 2 May 1792
12
Maranda Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.5.10]
b. Abt 1794
12
Barbara Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.5.11]
b. 25 Jun 1797 d. 1822
12
Diana Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.5.12]
b. 6 Jan 1800 d. 17 Nov 1861
11
Thankful Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.6]
b. 23 Feb 1760 d. 25 May 1834
David Legg
b. 11 May 1756 d. 25 Apr 1844
12
Thankful Holbrook Legg
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.6.1]
b. Abt 1803
11
Mary Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.7]
b. 1 Feb 1762 d. 27 Dec 1814
John Benson
b. 1 Aug 1749 d. 18 May 1818
12
John Perry Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.7.1]
b. 22 Jul 1781 d. 21 Jan 1842 [
=>
]
12
George Washington Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.7.2]
b. 25 May 1783 d. 10 Nov 1855 [
=>
]
12
Jared Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.7.3]
b. 3 Feb 1785 d. 31 Jul 1854 [
=>
]
12
Abigail Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.7.4]
b. 13 Feb 1787 [
=>
]
12
Mary "Polly" Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.7.5]
b. 9 Jun 1788 d. 12 Jan 1864 [
=>
]
12
Phyba Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.7.6]
b. Abt 1790
12
Prudence Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.7.7]
b. 7 Jul 1795
12
Thankful Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.7.8]
b. 26 Nov 1799 d. 1 May 1852 [
=>
]
12
Sulvanus Holbrook Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.7.9]
b. 12 Jan 1797 d. 24 Aug 1812
12
Judson Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.7.10]
b. Abt 1801 d. 15 Oct 1813
11
Stephen Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.8]
b. 19 Jun 1764 d. 16 Aug 1830
Hope Albee
b. Abt 1765 d. 18 Jan 1840
12
Rachel Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.8.1]
b. 22 Apr 1789
12
Sylvanus Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.8.2]
b. 28 Jul 1792 d. 9 Dec 1855
12
Willard Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.8.3]
b. 7 Apr 1795 d. 4 Mar 1862
12
Wilder Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.8.4]
b. 7 Apr 1795 d. 2 Jan 1855
12
Chloe Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.8.5]
b. 13 Aug 1801 d. 11 Aug 1855
12
Henry Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.8.6]
b. 19 Apr 1804 d. 10 Jul 1874
12
Ellery Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.8.7]
b. 26 Jun 1810 d. 10 Jul 1847
11
Abigail Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.9]
b. 13 Sep 1765
11
Henry Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.10]
b. 11 Feb 1768 d. 18 Dec 1868
+
Barbara Thayer
b. 27 Feb 1770
11
Lucy Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.11]
b. 13 Sep 1770 d. 29 Jan 1843
Abner Adams
b. 4 Nov 1757 d. Aft 1831
12
Silvanus Adams
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.11.1]
b. 7 Oct 1796 d. 6 Feb 1872
12
Washington Adams
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.11.2]
b. 11 Dec 1799
12
Ruth Adams
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.11.3]
b. 11 May 1802
12
Harriet Thayer Adams
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.11.4]
b. 8 Oct 1804 d. 29 Oct 1825
12
Abner Adams
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.11.5]
b. 11 Feb 1806
12
Judson Adams
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.11.6]
b. 23 Mar 1808 d. 1843
12
Washington Adams
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.11.7]
b. 1810
12
Zebediah Adams
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.2.11.8]
b. 3 Aug 1814 d. 3 Apr 1815
10
John Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.3]
b. 1 Aug 1717 d. 1773
Zilphah Thayer
b. 14 Sep 1722 d. 1761
11
Micah Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.3.1]
b. 11 Mar 1744
11
Amariah Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.3.2]
b. Abt 1745 d. 20 Jan 1817
11
John Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.3.3]
b. Jun 1748
11
Catharina Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.3.4]
b. Abt 1752 d. 1752
11
Rhoda Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.3.5]
b. 25 Aug 1758 d. 1807
10
Sarah Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.4]
b. Abt 1719 d. 1800
Peter Thayer
b. 16 Apr 1720 d. Aft 1761
11
Naomi Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.4.1]
b. 4 Jul 1751
Stephen Corrary
b. 16 Dec 1746
12
Sarah Crary
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.4.1.1]
b. 21 Jul 1769
12
Ruth Crary
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.4.1.2]
b. 18 Feb 1771
12
Phoebe Crary
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.4.1.3]
b. 21 May 1775
12
Chloe Crary
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.4.1.4]
b. 21 Apr 1777
12
Joanna Crary
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.4.1.5]
b. 7 Feb 1779
12
Rachel Crary
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.4.1.6]
b. 18 Jun 1780
12
Phoebe Crary
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.4.1.7]
b. 13 May 1782
12
Stephen Crary
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.4.1.8]
b. 1 Jun 1784
12
Sullivan Crary
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.4.1.9]
b. 18 Apr 1786
11
Reuben Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.4.2]
b. 27 Jun 1753 d. 9 Jun 1804
Abigail Wood
b. 30 Aug 1759 d. 22 Jun 1845
12
Chloe Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.4.2.1]
b. 8 Nov 1781 d. Abt 1870 [
=>
]
12
Abigail Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.4.2.2]
b. 11 Oct 1782 [
=>
]
12
Eunice Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.4.2.3]
b. May 1785 d. Mar 1790
12
Reuben Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.4.2.4]
b. 6 Oct 1786 d. 8 Nov 1860 [
=>
]
12
Salley Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.4.2.5]
b. 9 Feb 1790 d. 1835
12
Sylvanus Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.4.2.6]
b. 1793
12
Eunice Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.4.2.7]
b. 5 Mar 1797 [
=>
]
12
George Washington Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.4.2.8]
b. 5 Aug 1799 d. 7 Mar 1865 [
=>
]
11
Peter Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.4.3]
b. 2 Oct 1755 d. 1820
Abigail Green
b. 4 Oct 1765 d. 1830
12
Betsy Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.4.3.1]
b. 14 Jul 1784 d. 7 Aug 1821 [
=>
]
12
Emery Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.4.3.2]
b. 27 Jan 1786 d. 19 May 1851 [
=>
]
12
Samuel Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.4.3.3]
b. 30 Apr 1788 d. 1851 [
=>
]
12
Hyram Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.4.3.4]
b. Abt 1790 [
=>
]
12
John H Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.4.3.5]
b. 25 May 1791 [
=>
]
12
Henry Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.4.3.6]
b. 23 Mar 1793 d. Abt 1825 [
=>
]
12
Peter Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.4.3.7]
b. 15 Jul 1795 [
=>
]
12
Oliver Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.4.3.8]
b. 21 Oct 1796
12
Abigail Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.4.3.9]
b. 9 Jul 1803
12
Sylvanus Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.4.3.10]
b. 9 Aug 1806 [
=>
]
11
Oliver Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.4.4]
b. 9 Jul 1758
11
Silvanus Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.4.5]
b. 4 Sep 1762
+
Diana Taft
b. 4 Sep 1767 d. 1830
11
Hannah Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.4.6]
b. 8 Jul 1764
+
Joseph Crossman
b. Abt 1758
10
Catherine Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.5]
b. Abt 1721 d. 1740
Daniel Holbrook
b. 1717 d. 1765
11
Job Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.5.1]
b. 17 Mar 1751
11
Annah Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.5.2]
b. 2 Apr 1754
11
Phinehas Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.5.3]
b. 8 Apr 1760
11
Paul Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.5.4]
b. 29 Jan 1756
11
Peter Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.5.5]
b. 1 Mar 1745
11
Catharina Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.5.6]
b. 1752
11
Silas Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.5.7]
b. 11 Oct 1762
11
Daniel Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.5.8]
b. 6 Mar 1743 d. Bef 1758
11
Daniel Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.5.9]
b. 12 Mar 1758
10
Eunice Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.6]
b. 9 Aug 1735 d. Aft 1790
Moses Benson
b. 20 May 1732 d. 3 Jul 1806
11
Aaron Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.6.1]
b. 28 Oct 1753 d. 8 Jul 1827
Lydia Fairbanks
b. 1758 d. 30 Aug 1814
12
Alanson Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.6.1.1]
b. 1783 d. 7 Dec 1857 [
=>
]
12
Polly Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.6.1.2]
b. 9 Apr 1785 d. 3 Dec 1847 [
=>
]
12
Aaron Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.6.1.3]
b. 10 Mar 1788
12
Ellis Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.6.1.4]
b. 13 Oct 1792 d. 31 Mar 1830
12
Lydia Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.6.1.5]
b. 15 Oct 1798 [
=>
]
11
David Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.6.2]
b. 23 Dec 1756 d. 8 Mar 1847
Zilla Marsh
b. 29 Aug 1760 d. 18 Jan 1817
12
Jessie Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.6.2.1]
b. 14 Mar 1781 d. Abt 1846 [
=>
]
12
Betsey Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.6.2.2]
b. 27 Jun 1782
12
Asenath Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.6.2.3]
b. 16 Feb 1784
12
Phineas Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.6.2.4]
b. 31 May 1785 d. 15 Mar 1835 [
=>
]
12
Levina Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.6.2.5]
b. 6 Sep 1786
12
Cyrus Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.6.2.6]
b. 23 Dec 1787
12
Matilda Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.6.2.7]
b. 10 Apr 1789
12
David Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.6.2.8]
b. 10 Apr 1789 d. 19 Oct 1868 [
=>
]
12
Moses Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.6.2.9]
b. 1 Oct 1792
12
Lewis Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.6.2.10]
b. 21 Jan 1794
12
Danford Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.6.2.11]
b. 1 Jul 1794 d. 14 Feb 1859 [
=>
]
12
Willard Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.6.2.12]
b. 7 Apr 1797
12
Susannah Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.6.2.13]
b. 7 Oct 1798 d. 4 Jan 1817
12
Hannah Azuba Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.6.2.14]
b. 4 Jul 1801
12
Albey Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.6.2.15]
b. 27 Aug 1804
11
Keziah Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.6.3]
b. 1 Mar 1759 d. Abt 1800
11
Daniel Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.6.4]
b. 1 Jun 1761 d. 9 Oct 1854
Phebe Bugbee
b. 1762 d. 3 May 1855
12
Annie Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.6.4.1]
b. 28 Mar 1787
12
Daniel Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.6.4.2]
b. 18 May 1788
12
John Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.6.4.3]
b. 19 Mar 1789
12
Mary Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.6.4.4]
b. 28 May 1791
12
Ebenezer Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.6.4.5]
b. 4 Sep 1793 d. 11 Mar 1870
12
Melinda Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.6.4.6]
b. 25 Jul 1795
12
Orrison Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.6.4.7]
b. 31 Aug 1797 d. 24 Apr 1883
12
Sally Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.6.4.8]
b. 30 Jul 1799 [
=>
]
12
Arza Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.6.4.9]
b. 7 Jul 1803
12
James Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.6.4.10]
b. 3 Jan 1805
12
Chester Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.6.4.11]
b. 26 Jan 1807 d. 19 Aug 1889 [
=>
]
12
Cynthia Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.6.4.12]
b. 16 Jan 1809
12
Fanny Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.6.4.13]
b. 2 Jun 1811
11
Peter Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.6.5]
b. 16 Jul 1763 d. 23 Mar 1854
11
Jesse Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.6.6]
b. 19 Feb 1766
11
Anna Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.6.7]
b. 6 Aug 1767
11
Hannah Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.6.8]
b. 3 Mar 1770
11
Susanna Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.6.9]
b. 26 Aug 1772
11
Eunice Benson
[1.3.3.1.1.3.4.4.4.6.10]
b. 4 May 1775
8
Captain Thomas Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5]
b. 14 Feb 1663 d. 1 May 1738
Alice Poole
b. 20 Nov 1668 d. 8 Dec 1745
9
Mary Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.1]
b. 16 Jan 1689 d. 26 Aug 1720
9
Thomas Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.2]
b. 14 Jan 1694 d. 10 Feb 1761
Ruth Darling
b. 20 Sep 1695 d. 8 Dec 1776
10
Priscilla Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.1]
b. 6 Jun 1717 d. Aft 1761
Lieutenant Moses Taft
b. 30 Jan 1712 d. 16 Jul 1778
11
Lieutenant Abner Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.1.1]
b. 28 Dec 1736 d. 30 May 1809
Tryal White
b. 8 May 1737 d. 14 Jun 1814
12
Oliver Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.1.1.1]
b. 1 May 1758 d. 16 Jul 1775
12
Moses Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.1.1.2]
b. 29 Sep 1760 d. 4 Dec 1848 [
=>
]
12
Mary Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.1.1.3]
b. 12 Oct 1767 d. 18 Aug 1775
12
Webb Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.1.1.4]
b. 26 Mar 1772 d. 21 Apr 1842 [
=>
]
12
Trial T Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.1.1.5]
b. 13 Apr 1777 d. 18 Aug 1815
11
James Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.1.2]
b. 9 Apr 1738 d. 14 Jan 1826
Esther Taft
b. 9 Jan 1747 d. 3 Feb 1834
12
Lucy Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.1.2.1]
b. 22 Nov 1769 d. 29 Jul 1845 [
=>
]
12
Zilpha Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.1.2.2]
b. 1 Jul 1772 d. 24 Feb 1848 [
=>
]
12
Irena Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.1.2.3]
b. 25 Oct 1774 d. 29 May 1790
12
Ezekial Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.1.2.4]
b. 21 Jan 1777 d. 24 Apr 1841
12
James Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.1.2.5]
b. 13 Jun 1780
12
Luke Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.1.2.6]
b. 3 Jun 1783 [
=>
]
12
Esther Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.1.2.7]
b. 5 Aug 1786 d. 10 Aug 1858 [
=>
]
12
Moses Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.1.2.8]
b. 14 Jul 1788 d. 26 Jun 1810
12
Abigail Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.1.2.9]
b. 24 Jan 1791 d. 15 May 1837 [
=>
]
11
Ruth Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.1.3]
b. 19 Feb 1740 d. 27 Jun 1797
11
Moses Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.1.4]
b. 21 Dec 1742
11
Margaret Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.1.5]
b. 19 Feb 1743 d. 3 Oct 1761
11
Nahum Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.1.6]
b. 17 Aug 1745
11
Priscilla Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.1.7]
b. 30 Apr 1749 d. 12 Sep 1833
Timothy Taft
b. 3 Apr 1750 d. 30 Nov 1808
12
Marcy Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.1.7.1]
b. 28 Sep 1771 d. 1 Aug 1848
12
Josiah Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.1.7.2]
b. 3 May 1774
12
Abigail Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.1.7.3]
b. 14 Jan 1777 d. 17 Dec 1832 [
=>
]
12
Polly Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.1.7.4]
b. 1779 d. 5 Sep 1785
12
Timothy Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.1.7.5]
b. 1782 d. 5 Jan 1818 [
=>
]
12
Joseph Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.1.7.6]
b. 1784
12
Jonas Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.1.7.7]
b. 1786
12
Polly Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.1.7.8]
b. 1788 d. 1859
11
Joseph Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.1.8]
b. 6 Jul 1751 d. 2 Jul 1828
Hannah Keith
b. 17 Jul 1753 d. 2 Apr 1842
12
Oliver Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.1.8.1]
b. 6 Nov 1771 d. 20 Feb 1853 [
=>
]
12
Huldah Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.1.8.2]
b. 17 Feb 1775 d. Bef 21 May 1780
12
Huldah Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.1.8.3]
b. 21 May 1780 d. 11 Oct 1811 [
=>
]
12
Hannah Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.1.8.4]
b. 29 Sep 1783
12
Peter Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.1.8.5]
b. 24 Apr 1786
11
Luke Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.1.9]
b. 10 Aug 1754
11
Joanna Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.1.10]
b. 26 Jun 1756 d. 30 Sep 1761
11
Josiah Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.1.11]
b. 1 Oct 1758 d. 29 Sep 1761
10
Elisabeth Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.2]
b. 29 Jan 1719 d. 1725
10
Peter Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.3]
b. 16 Apr 1720 d. Aft 1761
Sarah Holbrook
b. Abt 1719 d. 1800
11
Naomi Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.3.1]
b. 4 Jul 1751
Stephen Corrary
b. 16 Dec 1746
12
Sarah Crary
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.3.1.1]
b. 21 Jul 1769
12
Ruth Crary
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.3.1.2]
b. 18 Feb 1771
12
Phoebe Crary
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.3.1.3]
b. 21 May 1775
12
Chloe Crary
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.3.1.4]
b. 21 Apr 1777
12
Joanna Crary
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.3.1.5]
b. 7 Feb 1779
12
Rachel Crary
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.3.1.6]
b. 18 Jun 1780
12
Phoebe Crary
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.3.1.7]
b. 13 May 1782
12
Stephen Crary
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.3.1.8]
b. 1 Jun 1784
12
Sullivan Crary
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.3.1.9]
b. 18 Apr 1786
11
Reuben Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.3.2]
b. 27 Jun 1753 d. 9 Jun 1804
Abigail Wood
b. 30 Aug 1759 d. 22 Jun 1845
12
Chloe Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.3.2.1]
b. 8 Nov 1781 d. Abt 1870 [
=>
]
12
Abigail Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.3.2.2]
b. 11 Oct 1782 [
=>
]
12
Eunice Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.3.2.3]
b. May 1785 d. Mar 1790
12
Reuben Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.3.2.4]
b. 6 Oct 1786 d. 8 Nov 1860 [
=>
]
12
Salley Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.3.2.5]
b. 9 Feb 1790 d. 1835
12
Sylvanus Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.3.2.6]
b. 1793
12
Eunice Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.3.2.7]
b. 5 Mar 1797 [
=>
]
12
George Washington Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.3.2.8]
b. 5 Aug 1799 d. 7 Mar 1865 [
=>
]
11
Peter Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.3.3]
b. 2 Oct 1755 d. 1820
Abigail Green
b. 4 Oct 1765 d. 1830
12
Betsy Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.3.3.1]
b. 14 Jul 1784 d. 7 Aug 1821 [
=>
]
12
Emery Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.3.3.2]
b. 27 Jan 1786 d. 19 May 1851 [
=>
]
12
Samuel Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.3.3.3]
b. 30 Apr 1788 d. 1851 [
=>
]
12
Hyram Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.3.3.4]
b. Abt 1790 [
=>
]
12
John H Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.3.3.5]
b. 25 May 1791 [
=>
]
12
Henry Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.3.3.6]
b. 23 Mar 1793 d. Abt 1825 [
=>
]
12
Peter Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.3.3.7]
b. 15 Jul 1795 [
=>
]
12
Oliver Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.3.3.8]
b. 21 Oct 1796
12
Abigail Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.3.3.9]
b. 9 Jul 1803
12
Sylvanus Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.3.3.10]
b. 9 Aug 1806 [
=>
]
11
Oliver Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.3.4]
b. 9 Jul 1758
11
Silvanus Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.3.5]
b. 4 Sep 1762
+
Diana Taft
b. 4 Sep 1767 d. 1830
11
Hannah Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.3.6]
b. 8 Jul 1764
+
Joseph Crossman
b. Abt 1758
10
Thomas Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.4]
b. 23 Jan 1721 d. 26 Jul 1770
10
Temperance Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.5]
b. 3 Jan 1729 d. 24 Feb 1812
10
Oliver Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.6]
b. 13 Mar 1730 d. Bef 1759
10
Joseph Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.7]
b. 10 Mar 1734
10
Elizabeth Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.8]
b. 13 Feb 1724 d. 27 Aug 1797
Captain Joseph Taft
b. 19 Apr 1722 d. 25 Dec 1787
11
Rueben Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.8.1]
b. 21 Oct 1742 d. Aft 1761
Faithful Thayer
b. 18 Jun 1744 d. 1827
12
Susannah Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.8.1.1]
b. 27 Dec 1761 d. 14 Nov 1825 [
=>
]
12
Nancy Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.8.1.2]
b. 9 Jul 1763 d. 1835
12
Rhoxanna Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.8.1.3]
b. 14 Aug 1765 d. 1837
12
Diana Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.8.1.4]
b. 4 Sep 1767 d. 1830
12
Joseph Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.8.1.5]
b. 26 Jun 1769
12
Marcy Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.8.1.6]
b. 11 Aug 1771 d. 1840
12
Polly Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.8.1.7]
b. 9 Jun 1773 d. 26 Oct 1848 [
=>
]
12
Ruth Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.8.1.8]
b. 5 Jul 1778 d. 1860 [
=>
]
12
Betsy Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.8.1.9]
b. 24 Mar 1776 d. Feb 1853 [
=>
]
11
Lucy Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.8.2]
b. 5 Mar 1745 d. 1822
11
Silas Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.8.3]
b. 22 Nov 1747
11
Sarah Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.8.4]
b. 8 Mar 1750 d. 3 May 1811
11
Asahel Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.8.5]
b. 30 Jul 1752 d. Nov 1826
Rachel Alton
b. 9 Mar 1760 d. 5 Aug 1851
12
Silas Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.8.5.1]
b. 21 Oct 1780
12
Elizabeth Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.8.5.2]
b. 17 Mar 1783
12
Rachel Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.8.5.3]
b. Abt 1785
12
Mary Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.8.5.4]
b. 1787
12
Asahel J Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.8.5.5]
b. 1792
12
Joseph Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.8.5.6]
b. 15 Jun 1794
12
Sarah Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.8.5.7]
b. 28 Feb 1797 d. 29 Sep 1879 [
=>
]
12
Fannie Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.8.5.8]
b. 14 Jan 1801 d. 3 Sep 1867
12
Emily Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.8.5.9]
b. 8 Mar 1803
11
Ezra Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.8.6]
b. 22 Dec 1752 d. Aft 1803
11
Ruth Taft
[1.3.3.1.1.3.4.5.2.8.7]
b. 13 May 1763
9
Samuel Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3]
b. 28 Mar 1696 d. 21 Jun 1764
Mary Sampson
b. Abt 1694 d. 12 Mar 1723
10
Abigail Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.1]
b. 22 Aug 1718 d. 11 Mar 1774
John Partridge
b. 2 Jun 1715 d. 21 Dec 1791
11
John Partridge
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.1.1]
b. Abt 1737 d. 14 May 1764
11
Asa Partridge
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.1.2]
b. 24 Jul 1740 d. 10 Dec 1746
11
Joseph Partridge
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.1.3]
b. 26 Oct 1742 d. 10 Oct 1746
11
Samuel Partridge
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.1.4]
b. 15 Apr 1743 d. 15 Apr 1744
11
Stephen Partridge
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.1.5]
b. 15 Apr 1744 d. 15 Apr 1744
11
Abigail Partridge
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.1.6]
b. 26 Oct 1745 d. 20 Feb 1746
11
Micah Partridge
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.1.7]
b. 20 Dec 1746 d. 20 Dec 1746
11
Abigail Allen Partridge
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.1.8]
b. 23 Jan 1754 d. 12 May 1802
10
Samuel Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.2]
b. 10 Jun 1721 bur. 24 Nov 1789
Sarah Farnham
b. 20 Jul 1736 d. 1778
11
Amos Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.2.1]
b. 19 Aug 1757 d. 11 Jul 1838
11
Jabes Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.2.2]
b. Abt 1758 d. 1778
11
Asa Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.2.3]
b. 4 Oct 1761 d. 9 Apr 1828
Mary Murdock
b. 15 Jun 1764 d. 26 Jul 1844
12
Olive Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.2.3.1]
b. 10 Aug 1782 d. 1865
12
Clinton Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.2.3.2]
b. 27 Apr 1784 d. 7 Mar 1835
12
Nancy Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.2.3.3]
b. 1786 d. 1852 [
=>
]
12
Royal Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.2.3.4]
b. 1787
12
Sullivan Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.2.3.5]
b. 3 Apr 1792 d. 7 Nov 1865
12
Emery Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.2.3.6]
b. 19 Feb 1794 d. 12 Aug 1862
12
Louis Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.2.3.7]
b. 3 Oct 1796 d. 1832
12
Mary M Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.2.3.8]
b. Abt 1799 d. 1885
12
Asa Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.2.3.9]
b. 2 Sep 1799 d. 1871
12
Turner Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.2.3.10]
b. 2 Feb 1802 d. 8 Dec 1853
12
Lovisa Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.2.3.11]
b. 4 Apr 1806 d. 1828
12
Collins Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.2.3.12]
b. 7 Apr 1790 d. 19 Sep 1855 [
=>
]
11
Samuel Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.2.4]
b. 6 Sep 1762 d. 1830
+
Rebecca Howe
b. 4 Dec 1763 d. 17 Aug 1829
11
Loies Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.2.5]
b. 15 Feb 1764 d. 1837
11
Polly Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.2.6]
b. 18 Feb 1766 d. 1843
11
Eunice Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.2.7]
b. 1768 d. 1841
11
Louisa Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.2.8]
b. 1774 d. 1829
10
Zilphah Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.3]
b. 14 Sep 1722 d. 1761
John Holbrook
b. 1 Aug 1717 d. 1773
11
Micah Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.3.1]
b. 11 Mar 1744
11
Amariah Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.3.2]
b. Abt 1745 d. 20 Jan 1817
11
John Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.3.3]
b. Jun 1748
11
Catharina Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.3.4]
b. Abt 1752 d. 1752
11
Rhoda Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.3.5]
b. 25 Aug 1758 d. 1807
10
Mary Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.4]
b. 12 Feb 1723 d. 7 Aug 1764
10
Thankful Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5]
b. 4 Aug 1725 d. 10 Dec 1798
Sylvanus Holbrook
b. 13 May 1713 d. 1782
11
Sylvanus Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.1]
b. 21 Apr 1750 d. 1828
Mary Thayer
b. 7 Jun 1749 d. 26 May 1831
12
Phebe Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.1.1]
b. 16 Feb 1773 d. 25 Oct 1832
12
Ezekiel Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.1.2]
b. 18 Apr 1777 d. 1799
12
Joseph Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.1.3]
b. 6 Nov 1781
12
Polly Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.1.4]
b. 1783
12
Mary Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.1.5]
b. 16 Oct 1784 d. 15 Aug 1844
11
Ruth Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.2]
b. 10 Aug 1751 d. 16 May 1781
Benoni Benson
b. 11 Jul 1747 d. 1803
12
Amasa Benson
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.2.1]
b. 25 Jan 1771 d. 7 Mar 1837 [
=>
]
12
Chloe Benson
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.2.2]
b. 28 Jan 1774
12
Benoni Benson
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.2.3]
b. 1780 d. 1819
11
Rachel Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.3]
b. 6 Nov 1753 d. 9 Mar 1832
Jonathan Staples
b. 29 Mar 1754 d. 28 Nov 1832
12
Sally Staples
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.3.1]
b. 3 Oct 1779
12
Sylvia Staples
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.3.2]
b. 2 Jan 1781 d. 13 Mar 1852
12
Rachael Staples
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.3.3]
b. Abt 1784 d. 12 Dec 1870
12
Ellery Staples
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.3.4]
b. 1784 d. 1861
12
Willard Staples
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.3.5]
b. 20 Dec 1785 d. 20 Dec 1858
12
Jonathan Staples
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.3.6]
b. 1792
11
Comfort Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.4]
b. 12 Mar 1756
11
Margaret Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.5]
b. 14 Aug 1757 d. Abt 1805
Thadaus Thayer
b. 1 Feb 1754 d. 24 Dec 1826
12
George Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.5.1]
b. 20 Jul 1779 d. 27 May 1836
12
Otis Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.5.2]
b. 17 Mar 1780 d. 13 Apr 1841
12
Arkey Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.5.3]
b. 6 Dec 1781 d. 1783
12
Ellis Holbrook Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.5.4]
b. 9 Mar 1783 d. 2 Jul 1863
12
Ruth Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.5.5]
b. Abt 1784 d. 1821
12
Sylvanus Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.5.6]
b. Abt 1786 d. 7 Mar 1859
12
Margaret Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.5.7]
b. 11 Nov 1787
12
Thaddeus Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.5.8]
b. Nov 1789 d. 4 Mar 1824
12
Margery Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.5.9]
b. 2 May 1792
12
Maranda Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.5.10]
b. Abt 1794
12
Barbara Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.5.11]
b. 25 Jun 1797 d. 1822
12
Diana Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.5.12]
b. 6 Jan 1800 d. 17 Nov 1861
11
Thankful Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.6]
b. 23 Feb 1760 d. 25 May 1834
David Legg
b. 11 May 1756 d. 25 Apr 1844
12
Thankful Holbrook Legg
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.6.1]
b. Abt 1803
11
Mary Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.7]
b. 1 Feb 1762 d. 27 Dec 1814
John Benson
b. 1 Aug 1749 d. 18 May 1818
12
John Perry Benson
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.7.1]
b. 22 Jul 1781 d. 21 Jan 1842 [
=>
]
12
George Washington Benson
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.7.2]
b. 25 May 1783 d. 10 Nov 1855 [
=>
]
12
Jared Benson
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.7.3]
b. 3 Feb 1785 d. 31 Jul 1854 [
=>
]
12
Abigail Benson
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.7.4]
b. 13 Feb 1787 [
=>
]
12
Mary "Polly" Benson
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.7.5]
b. 9 Jun 1788 d. 12 Jan 1864 [
=>
]
12
Phyba Benson
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.7.6]
b. Abt 1790
12
Prudence Benson
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.7.7]
b. 7 Jul 1795
12
Thankful Benson
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.7.8]
b. 26 Nov 1799 d. 1 May 1852 [
=>
]
12
Sulvanus Holbrook Benson
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.7.9]
b. 12 Jan 1797 d. 24 Aug 1812
12
Judson Benson
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.7.10]
b. Abt 1801 d. 15 Oct 1813
11
Stephen Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.8]
b. 19 Jun 1764 d. 16 Aug 1830
Hope Albee
b. Abt 1765 d. 18 Jan 1840
12
Rachel Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.8.1]
b. 22 Apr 1789
12
Sylvanus Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.8.2]
b. 28 Jul 1792 d. 9 Dec 1855
12
Willard Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.8.3]
b. 7 Apr 1795 d. 4 Mar 1862
12
Wilder Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.8.4]
b. 7 Apr 1795 d. 2 Jan 1855
12
Chloe Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.8.5]
b. 13 Aug 1801 d. 11 Aug 1855
12
Henry Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.8.6]
b. 19 Apr 1804 d. 10 Jul 1874
12
Ellery Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.8.7]
b. 26 Jun 1810 d. 10 Jul 1847
11
Abigail Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.9]
b. 13 Sep 1765
11
Henry Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.10]
b. 11 Feb 1768 d. 18 Dec 1868
+
Barbara Thayer
b. 27 Feb 1770
11
Lucy Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.11]
b. 13 Sep 1770 d. 29 Jan 1843
Abner Adams
b. 4 Nov 1757 d. Aft 1831
12
Silvanus Adams
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.11.1]
b. 7 Oct 1796 d. 6 Feb 1872
12
Washington Adams
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.11.2]
b. 11 Dec 1799
12
Ruth Adams
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.11.3]
b. 11 May 1802
12
Harriet Thayer Adams
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.11.4]
b. 8 Oct 1804 d. 29 Oct 1825
12
Abner Adams
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.11.5]
b. 11 Feb 1806
12
Judson Adams
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.11.6]
b. 23 Mar 1808 d. 1843
12
Washington Adams
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.11.7]
b. 1810
12
Zebediah Adams
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.5.11.8]
b. 3 Aug 1814 d. 3 Apr 1815
10
Comfort Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.6]
b. 28 Jul 1728 bur. 17 Oct 1761
+
Samuel Fish
b. Abt 1728
10
Margaret Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.7]
b. 20 Mar 1730
Jonathan Farnham
b. 21 Apr 1739 d. 4 Mar 1816
11
Oliver Farnham
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.7.1]
b. Dec 1753
10
Susanna Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.8]
b. 14 Sep 1731
Elisha Hale
b. 11 Jan 1728 d. 6 Oct 1809
11
James Hale
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.8.1]
b. 16 Feb 1753
11
Simeon Hale
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.8.2]
b. 6 Mar 1756
10
Stephen Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.9]
b. 26 Sep 1733
Rachel Davis
b. 29 Dec 1741 d. 14 Jan 1816
11
Philidelphia Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.9.1]
b. 10 Nov 1763 d. 1843
11
Phylidelphia Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.9.2]
b. 10 Nov 1763 d. 1843
11
Nathan Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.9.3]
b. 22 Dec 1763 d. 1 May 1812
11
Stephen Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.9.4]
b. 14 Mar 1765 d. 3 Mar 1819
11
Rachel Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.9.5]
b. 1769
11
Nancy Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.9.6]
b. 24 May 1771 d. 27 May 1822
11
Limon Alanson Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.9.7]
b. 1772
11
Dolinda Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.9.8]
b. 13 Apr 1774
11
Nahum Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.9.9]
b. Abt 1776 d. 1811
11
Windsor Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.9.10]
b. 21 Jun 1778
11
Aaron Chance Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.9.11]
b. 29 Jan 1780 d. 27 Jul 1856
11
Lucinda Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.9.12]
b. 1 Jan 1782 d. 5 Nov 1828
10
Olive Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.3.10]
b. Abt 1735
+
Farnum
b. Abt 1731 d. Abt 1757
9
Temperance Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.4]
b. 7 Jul 1698 d. 7 Apr 1760
9
David Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.5]
b. 8 Feb 1700 d. Abt 7 Nov 1750
9
Elizabeth Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.6]
b. 2 Mar 1703 d. 8 Aug 1747
William White
b. 10 Nov 1696 d. 1745
10
Huldah White
[1.3.3.1.1.3.4.5.6.1]
b. 27 Aug 1722 d. Jul 1769
10
Lydia White
[1.3.3.1.1.3.4.5.6.2]
b. 1 Mar 1726
Abraham Staples
b. 3 Apr 1706 d. Aug 1767
11
Deborah Staples
[1.3.3.1.1.3.4.5.6.2.1]
b. 1741
11
Isaac Staples
[1.3.3.1.1.3.4.5.6.2.2]
b. 9 Mar 1742 d. 29 May 1848
Esther Benson
b. 8 Dec 1768 d. 31 Mar 1855
12
Esther Staples
[1.3.3.1.1.3.4.5.6.2.2.1]
b. Abt 1790 d. 17 May 1878
12
Abraham Staples
[1.3.3.1.1.3.4.5.6.2.2.2]
b. 12 Mar 1792 d. 5 Sep 1881
12
Scammel Staples
[1.3.3.1.1.3.4.5.6.2.2.3]
b. 29 Dec 1798 d. 5 Apr 1883
12
Warren Staples
[1.3.3.1.1.3.4.5.6.2.2.4]
b. 17 Jan 1802
12
Evaline Staples
[1.3.3.1.1.3.4.5.6.2.2.5]
b. 11 Aug 1807 d. 2 Oct 1858
11
Ruth Staples
[1.3.3.1.1.3.4.5.6.2.3]
b. 11 Jan 1744 d. 15 Dec 1819
11
Hammutal Staples
[1.3.3.1.1.3.4.5.6.2.4]
b. 16 Sep 1753
11
Nahor Staples
[1.3.3.1.1.3.4.5.6.2.5]
b. 3 Feb 1756 d. 9 Feb 1820
10
Ruth White
[1.3.3.1.1.3.4.5.6.3]
b. 10 Apr 1728
10
Jemina White
[1.3.3.1.1.3.4.5.6.4]
b. 26 Jul 1730
10
William White
[1.3.3.1.1.3.4.5.6.5]
b. 22 Nov 1732 d. 8 Apr 1800
10
Son White
[1.3.3.1.1.3.4.5.6.6]
b. 8 Mar 1734
10
Joseph White
[1.3.3.1.1.3.4.5.6.7]
b. 8 Mar 1735 d. 1735
10
Mary White
[1.3.3.1.1.3.4.5.6.8]
b. 31 Aug 1737
10
Elizabeth White
[1.3.3.1.1.3.4.5.6.9]
b. 5 Oct 1740
10
Elisha White
[1.3.3.1.1.3.4.5.6.10]
b. 16 Jan 1742 d. 24 Jun 1811
9
John Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.7]
b. 17 Sep 1705 d. 21 Mar 1779
9
William Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.8]
b. 22 Jan 1707 d. 7 Dec 1769
9
Margaret Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.9]
b. 12 Dec 1710 d. 4 Nov 1791
9
Jemima Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.5.10]
b. 13 Feb 1712 d. Abt 1734
8
David Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6]
b. 14 Feb 1664 d. Dec 1754
Mary Hayward
b. Abt 1660 d. 9 Mar 1729
9
Mary Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.1]
b. 22 Dec 1704 d. 24 Jun 1787
9
John Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.2]
b. 17 Sep 1706 d. Aft 1769
Rhuhamah Smith
b. Abt 1705 d. Bef 1769
10
Pelatiah Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.2.1]
b. 13 Oct 1739 d. 23 Mar 1797
Hannah Thayer
b. Abt 1744
11
Robert Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.2.1.1]
b. 22 Nov 1763 d. 1830
11
Artemas Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.2.1.2]
b. 20 Feb 1765 d. 1849
11
Henry Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.2.1.3]
b. 19 Sep 1768 d. 1776
11
Smith P Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.2.1.4]
b. 15 Dec 1770 d. 31 Mar 1818
11
Lavon Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.2.1.5]
b. 14 Mar 1773
11
Laban Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.2.1.6]
b. 19 Mar 1773 d. 1792
11
Putman Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.2.1.7]
b. 15 Aug 1774 d. 14 Nov 1776
11
Henry Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.2.1.8]
b. 3 Nov 1777 d. 7 Jul 1824
Urana Thompson
b. Abt 1778 d. 1859
12
Urana Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.2.1.8.1]
b. 26 Dec 1801 d. 15 Nov 1822 [
=>
]
12
Sarah Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.2.1.8.2]
b. 1802 d. 23 Jul 1847
12
Alice Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.2.1.8.3]
b. 1 Dec 1803 d. 29 Mar 1825
12
Betsey Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.2.1.8.4]
b. 6 Mar 1806 d. 9 Mar 1809
12
Preserved Smith Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.2.1.8.5]
b. 9 May 1808 [
=>
]
12
Henry Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.2.1.8.6]
b. 9 Oct 1810
12
Nancy Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.2.1.8.7]
b. 16 Oct 1815 d. 27 May 1831
12
Harriet Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.2.1.8.8]
b. 7 Feb 1819
12
Hannah Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.2.1.8.9]
b. 11 Feb 1820 [
=>
]
12
Edward Davis Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.2.1.8.10]
b. 22 Jul 1822 d. 12 May 1903
11
Mary Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.2.1.9]
b. 3 Nov 1777
11
John Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.2.1.10]
b. 20 Feb 1784 d. 5 Nov 1829
10
Rhuama Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.2.2]
b. 3 Jan 1742
10
Desire Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.2.3]
b. 11 Oct 1745
10
Robert Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.2.4]
b. 26 Nov 1749
10
Barbara Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.2.5]
b. 27 Feb 1770
+
Henry Holbrook
b. 11 Feb 1768 d. 18 Dec 1868
10
Betsey Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.2.6]
b. 28 Apr 1773 d. 1787
9
Moses Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.3]
b. 10 May 1710 d. 24 May 1764
9
Samuel Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.4]
b. 1713 bur. Aft 1756
9
Joseph Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5]
b. 8 May 1715 d. 1787
Sarah Balcom
b. 5 Apr 1720 d. 30 Dec 1769
10
Thirza Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.1]
b. 28 Dec 1741 d. 1810
10
Joseph Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.2]
b. Abt 1742
Rachel Jefferson
b. 28 Sep 1745
11
Rosanna Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.2.1]
b. 1766
11
Stephen Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.2.2]
b. 3 Dec 1768
Prudence White
b. Abt 1770 d. 1832
12
Adolphus Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.2.2.1]
b. 23 Oct 1790
12
Rachel Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.2.2.2]
b. 23 Oct 1790 d. 1858
12
Mary Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.2.2.3]
b. Sep 1794
12
Martha Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.2.2.4]
b. Abt 1795
12
Willis Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.2.2.5]
b. Abt 1796
12
Alice Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.2.2.6]
b. 1797
12
Smith Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.2.2.7]
b. 2 Feb 1798
12
Sarah S Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.2.2.8]
b. 3 May 1800 d. 28 Dec 1861
12
William Waldo Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.2.2.9]
b. 9 Mar 1802 [
=>
]
12
Prudence Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.2.2.10]
b. Mar 1804
12
Ruth Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.2.2.11]
b. 20 Apr 1806
11
Anna Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.2.3]
b. 1770
11
Moses Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.2.4]
b. Abt 1770 d. 1856
11
Rhoda Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.2.5]
b. Abt 1774
11
Olive Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.2.6]
b. Abt 1776 d. 10 Jan 1832
11
Rachel Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.2.7]
b. Abt 1778
11
Joseph Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.2.8]
b. 14 Jun 1780 d. 11 Jan 1852
10
Rhoda Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.3]
b. 11 Nov 1746 d. 20 Sep 1776
10
Sarah Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.4]
b. 1748 d. 22 Aug 1753
10
Mary Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.5]
b. 7 Jun 1749 d. 26 May 1831
Sylvanus Holbrook
b. 21 Apr 1750 d. 1828
11
Phebe Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.5.1]
b. 16 Feb 1773 d. 25 Oct 1832
11
Ezekiel Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.5.2]
b. 18 Apr 1777 d. 1799
11
Joseph Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.5.3]
b. 6 Nov 1781
11
Polly Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.5.4]
b. 1783
11
Mary Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.5.5]
b. 16 Oct 1784 d. 15 Aug 1844
10
Phoebe Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.6]
b. 11 Feb 1750 d. 9 Nov 1795
Abraham Cummings
b. 4 Jan 1755 d. 31 Aug 1827
11
Pheba Cummings
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.6.1]
b. 27 Aug 1783 d. Abt 1845
11
Ebenezer Cummings
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.6.2]
b. Abt 1785
11
Jabez Cummings
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.6.3]
b. Abt 1787 d. Abt 1797
11
Phebe Cummings
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.6.4]
b. 16 Oct 1799
10
John Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.7]
b. 28 Sep 1752 d. 25 Mar 1832
Dacy Richardson
b. Abt 1753 d. 1835
11
Sarah Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.7.1]
b. 30 Nov 1777
11
John Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.7.2]
b. 20 Nov 1778 d. 1850
11
Aurelia Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.7.3]
b. 24 Feb 1780 d. 1810
11
John Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.7.4]
b. 1782 d. 1850
11
Joseph Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.7.5]
b. 9 Feb 1790 d. 1872
11
Phoebe Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.7.6]
b. 1792 d. 1819
11
Captain Marvel Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.7.7]
b. 11 Oct 1796 d. 1866
Lucinda Aldrich
b. 1795 d. 1872
12
Joseph Mowery Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.7.7.1]
b. 17 Nov 1821 [
=>
]
12
Chloe Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.7.7.2]
b. 30 Sep 1822
12
Sarah Smith Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.7.7.3]
b. 20 Feb 1825
12
Lucinda Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.7.7.4]
b. 8 Jul 1827
12
Diantha Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.7.7.5]
b. 7 Oct 1829
12
John S Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.7.7.6]
b. 8 May 1832
10
Thadaus Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.8]
b. 1 Feb 1754 d. 24 Dec 1826
Margaret Holbrook
b. 14 Aug 1757 d. Abt 1805
11
George Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.8.1]
b. 20 Jul 1779 d. 27 May 1836
11
Otis Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.8.2]
b. 17 Mar 1780 d. 13 Apr 1841
11
Arkey Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.8.3]
b. 6 Dec 1781 d. 1783
11
Ellis Holbrook Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.8.4]
b. 9 Mar 1783 d. 2 Jul 1863
11
Ruth Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.8.5]
b. Abt 1784 d. 1821
11
Sylvanus Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.8.6]
b. Abt 1786 d. 7 Mar 1859
11
Margaret Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.8.7]
b. 11 Nov 1787
11
Thaddeus Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.8.8]
b. Nov 1789 d. 4 Mar 1824
11
Margery Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.8.9]
b. 2 May 1792
11
Maranda Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.8.10]
b. Abt 1794
11
Barbara Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.8.11]
b. 25 Jun 1797 d. 1822
11
Diana Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.8.12]
b. 6 Jan 1800 d. 17 Nov 1861
10
George Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.9]
b. 11 Nov 1756
10
Sarah Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.10]
b. 18 Jun 1757 d. 25 Feb 1838
10
Martha Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.5.11]
b. 1 Jun 1762
9
Icahbod Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.6.6]
b. 31 Mar 1721 d. 10 Mar 1796
8
Josiah Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.7]
b. 14 Jan 1668 d. 27 Feb 1727
+
Margaret Holbrook
b. Abt 1670
8
Josiah Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.8]
b. 15 Feb 1669 d. 19 Dec 1721
Mercy Butterworth
b. 22 Jan 1663 d. Abt 1692
9
Sarah Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.8.1]
b. 25 May 1691 d. 20 Jun 1739
Benoni Benson
b. 1689 d. 4 Nov 1761
10
Joseph Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.1]
b. 14 Oct 1712 d. 24 Feb 1786
Martha Taft
b. 15 Jun 1708 d. 6 Jan 1753
11
Moses Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.1.1]
b. 20 May 1732 d. 3 Jul 1806
Eunice Holbrook
b. 9 Aug 1735 d. Aft 1790
12
Aaron Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.1.1.1]
b. 28 Oct 1753 d. 8 Jul 1827 [
=>
]
12
David Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.1.1.2]
b. 23 Dec 1756 d. 8 Mar 1847 [
=>
]
12
Keziah Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.1.1.3]
b. 1 Mar 1759 d. Abt 1800
12
Daniel Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.1.1.4]
b. 1 Jun 1761 d. 9 Oct 1854 [
=>
]
12
Peter Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.1.1.5]
b. 16 Jul 1763 d. 23 Mar 1854
12
Jesse Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.1.1.6]
b. 19 Feb 1766
12
Anna Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.1.1.7]
b. 6 Aug 1767
12
Hannah Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.1.1.8]
b. 3 Mar 1770
12
Susanna Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.1.1.9]
b. 26 Aug 1772
12
Eunice Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.1.1.10]
b. 4 May 1775
11
Joseph Benson, Jr
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.1.2]
b. 22 Oct 1735 d. 12 Jan 1818
11
Aaron Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.1.3]
b. 20 May 1738 d. 7 Nov
11
Benjamin Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.1.4]
b. 3 Mar 1742 d. 29 Mar 1802
Martha McNamara
b. 11 Mar 1745 d. 15 Sep 1806
12
Amasa Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.1.4.1]
b. 15 Mar 1770 d. 28 Oct 1777
12
Timothy Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.1.4.2]
b. 19 Aug 1771 d. 22 Oct 1777
12
Silence Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.1.4.3]
b. 30 Jul 1773 d. 10 Nov 1777
12
Hannah Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.1.4.4]
b. 18 Apr 1775 d. 22 Apr 1831
12
Martha Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.1.4.5]
b. 26 Feb 1777 [
=>
]
12
Amasa Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.1.4.6]
b. 15 Feb 1779 d. 22 Feb 1847
12
Silence Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.1.4.7]
b. 8 Aug 1781 d. 4 Sep 1829
12
Thankful Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.1.4.8]
b. 29 Aug 1783 d. 11 Apr 1808 [
=>
]
12
Benjamin Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.1.4.9]
b. 6 Jun 1786 d. 18 Mar 1815
12
Truelove Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.1.4.10]
b. 18 Nov 1788 d. 1 Aug 1837
11
Abner Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.1.5]
b. Abt 1750
Experience Muxsom
b. 1753
12
Martha Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.1.5.1]
b. 27 Oct 1771 d. 7 Dec 1850 [
=>
]
12
Lucy Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.1.5.2]
b. 16 Apr 1774 d. 11 Dec 1815
12
Dennis Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.1.5.3]
b. 24 Jan 1777
+
Susannah Smith
b. 8 Oct 1724 d. 1775
10
Sarah Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.2]
b. 28 Jul 1715 d. 1747
10
Martha Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.3]
b. 14 Apr 1718 d. Abt 1768
Joseph Sprague
b. Abt 1717 d. 1790
11
Mary Sprague
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.3.1]
b. 8 May 1755 d. 17 Jun 1832
11
Martha Sprague
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.3.2]
b. 26 Aug 1740 d. 1818
11
Ebenezer Sprague
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.3.3]
b. 16 Aug 1747 d. 17 Sep 1837
11
Nathaniel Sprague
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.3.4]
b. Abt 1753 d. 1835
11
Joseph Sprague
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.3.5]
b. 1738 d. 1818
11
Hosea Sprague
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.3.6]
b. Abt 1758 d. 20 Nov 1843
11
Sarah Sprague
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.3.7]
b. 24 Feb 1744 d. 23 Dec 1814
11
Jonathan Sprague
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.3.8]
b. 10 Aug 1742 d. 23 Dec 1814
10
Susanah Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.4]
b. 2 Aug 1721 d. Aft 1750
+
Aaron White
b. 22 May 1717 d. Abt 1760
10
Benoni Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.5]
b. 18 Jul 1724 d. 10 Jan 1806
Abigail White
b. 27 Jan 1723 d. 4 May 1751
11
Stephen Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.5.1]
b. 15 Jul 1742 d. 30 Jul 1823
Mary Holbrook
b. 15 Jul 1745 d. 1849
12
Ichabod Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.5.1.1]
b. 30 Dec 1764 d. Aug 1794 [
=>
]
12
Elkanah Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.5.1.2]
b. 21 Feb 1766 d. 8 Mar 1844 [
=>
]
12
Esther Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.5.1.3]
b. 8 Dec 1768 d. 31 Mar 1855 [
=>
]
12
Ezekial Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.5.1.4]
b. 13 Mar 1770
12
Phila Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.5.1.5]
b. 23 Feb 1772 [
=>
]
12
Polly Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.5.1.6]
b. 7 Nov 1773 [
=>
]
12
Sally Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.5.1.7]
b. 13 Feb 1776 d. 24 Nov 1837 [
=>
]
11
Henry Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.5.2]
b. 5 Dec 1743 d. 7 Dec 1777
Susanna Thayer
b. 23 Apr 1746 d. 4 Jan 1808
12
Hannah Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.5.2.1]
b. 7 May 1764
12
Joanna Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.5.2.2]
b. 6 Jul 1766 d. 29 Dec 1820 [
=>
]
12
Abigail Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.5.2.3]
b. 2 Jul 1768
12
Henry Staples Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.5.2.4]
b. 8 Aug 1770 d. 29 Jul 1821 [
=>
]
12
Tirza Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.5.2.5]
b. 29 Apr 1772 [
=>
]
12
Susanna Thayer Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.5.2.6]
b. 19 Feb 1775
12
Rachel Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.5.2.7]
b. 5 May 1777 d. 21 Nov 1842 [
=>
]
11
Joanna Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.5.3]
b. 14 Nov 1745 d. Bef 1806
11
Benoni Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.5.4]
b. 11 Jul 1747 d. 1803
Ruth Holbrook
b. 10 Aug 1751 d. 16 May 1781
12
Amasa Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.5.4.1]
b. 25 Jan 1771 d. 7 Mar 1837 [
=>
]
12
Chloe Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.5.4.2]
b. 28 Jan 1774
12
Benoni Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.5.4.3]
b. 1780 d. 1819
Ruth Sibley
b. 9 Apr 1745 d. 30 Nov 1814
12
John Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.5.4.4]
b. 1789
11
John Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.5.5]
b. 1 Aug 1749 d. 18 May 1818
Mary Holbrook
b. 1 Feb 1762 d. 27 Dec 1814
12
John Perry Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.5.5.1]
b. 22 Jul 1781 d. 21 Jan 1842 [
=>
]
12
George Washington Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.5.5.2]
b. 25 May 1783 d. 10 Nov 1855 [
=>
]
12
Jared Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.5.5.3]
b. 3 Feb 1785 d. 31 Jul 1854 [
=>
]
12
Abigail Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.5.5.4]
b. 13 Feb 1787 [
=>
]
12
Mary "Polly" Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.5.5.5]
b. 9 Jun 1788 d. 12 Jan 1864 [
=>
]
12
Phyba Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.5.5.6]
b. Abt 1790
12
Prudence Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.5.5.7]
b. 7 Jul 1795
12
Thankful Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.5.5.8]
b. 26 Nov 1799 d. 1 May 1852 [
=>
]
12
Sulvanus Holbrook Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.5.5.9]
b. 12 Jan 1797 d. 24 Aug 1812
12
Judson Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.5.5.10]
b. Abt 1801 d. 15 Oct 1813
Joanna Taft
b. 14 Nov 1751 d. 3 Oct 1777
12
Lovett Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.5.5.11]
b. 6 Oct 1772 d. 4 Mar 1773
12
Lois Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.5.5.12]
b. 17 Jul 1774 d. 10 Jul 1840 [
=>
]
12
Prudence Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.5.5.13]
b. 4 May 1776 d. 16 May 1789
11
Ichabod Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.5.6]
b. 4 May 1751 d. Bef 1806
Abigail Staples
b. 12 Oct 1729 d. 31 Dec 1813
11
Henry Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.5.7]
b. Abt 1778
11
Joseph Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.5.8]
b. Abt 1784
10
Abigail Benson
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.6]
b. 12 Aug 1731 d. 21 Dec 1813
Benjamin Holbrook
b. 14 Feb 1723 d. 1757
11
Son Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.6.1]
b. Abt 1748
11
Abigail Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.6.2]
b. 15 Aug 1749
11
Abiah Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.6.3]
b. 4 Mar 1752
11
Reuben Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.6.4]
b. 18 Jul 1754 d. 1835
Rachel Darling
b. 1 May 1755 d. Bef 1818
12
Abigail Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.6.4.1]
b. 8 Jan 1778
12
Rachael Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.6.4.2]
b. 8 Jan 1780 [
=>
]
12
Prudence Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.6.4.3]
b. 25 Feb 1782
12
Anna Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.6.4.4]
b. 30 Mar 1784 d. 16 Mar 1851 [
=>
]
12
Benjamin Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.8.1.6.4.5]
b. 31 Jan 1786
9
Hulda Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.8.2]
b. 11 Feb 1695 d. 1720
9
Mary Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.8.3]
b. 11 Feb 1701
9
Oliver Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.8.4]
b. 1 Aug 1704
9
Joseph Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.8.5]
b. 3 Jul 1707 d. 1734
9
Benjamin Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.8.6]
b. 11 Sep 1709 d. May 1761
9
Maria Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.8.7]
b. Abt 1711
9
Margaret Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.8.8]
b. Abt 1717
9
Zilphah Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.8.9]
b. 14 Sep 1722 d. 1761
John Holbrook
b. 1 Aug 1717 d. 1773
10
Micah Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.8.9.1]
b. 11 Mar 1744
10
Amariah Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.8.9.2]
b. Abt 1745 d. 20 Jan 1817
10
John Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.8.9.3]
b. Jun 1748
10
Catharina Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.8.9.4]
b. Abt 1752 d. 1752
10
Rhoda Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.8.9.5]
b. 25 Aug 1758 d. 1807
8
Ebenezer Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.9]
b. 1672 d. 13 Jun 1695
Martha Thompson
b. 28 Aug 1675 d. 14 Oct 1759
9
Ebenezer Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.9.1]
b. 6 Sep 1697 d. 5 May 1771
9
Abigail Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.9.2]
b. 2 Sep 1701 d. 25 Aug 1756
9
Jerusha Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.9.3]
b. Abt 1704
9
Hannah Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.9.4]
b. 15 Sep 1704 d. 20 May 1761
9
Martha Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.9.5]
b. 1705 d. 13 Nov 1757
9
Uriah Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.9.6]
b. 10 Sep 1706
Rachel Taft
b. 1 Oct 1704 d. 1752
10
Uriah Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.9.6.1]
b. 16 Mar 1728 d. 1796
10
Ebenezer Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.9.6.2]
b. 1731 d. 1775
10
Eleazer Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.9.6.3]
b. 1733 d. 1755
10
Rachel Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.9.6.4]
b. 19 Jun 1735 d. 1783
10
Martha Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.9.6.5]
b. 1736 d. 1807
10
Simeon Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.9.6.6]
b. 20 Oct 1739 d. 1764
9
Daniel Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.9.7]
b. 1709 d. 1756
9
Esther Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.9.8]
b. 6 Sep 1715
8
Benjamin Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.10]
b. 1674 d. 1729
Sarah Haywood
b. 2 Mar 1673 d. 8 Dec 1711
9
Rachel Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.10.1]
b. 5 Mar 1700 d. 1759
Eleazer Taft
b. 5 Apr 1697 d. 29 Aug 1759
10
Aaron Taft
[1.3.3.1.1.3.4.10.1.1]
b. 20 Jul 1722 d. 24 Apr 1764
10
Moses Taft
[1.3.3.1.1.3.4.10.1.2]
b. 20 Jul 1722 d. 12 Nov 1791
10
Sarah Taft
[1.3.3.1.1.3.4.10.1.3]
b. 2 Nov 1727
10
Joshua Taft
[1.3.3.1.1.3.4.10.1.4]
b. 14 Jan 1731 d. 1770
9
Margaret Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.10.2]
b. 17 Dec 1701 d. 20 Oct 1749
9
Grace Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.10.3]
b. 6 May 1704
9
Sarah Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.10.4]
b. 23 Mar 1706
9
Benjamin Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.10.5]
b. 23 Sep 1707 d. 23 Feb 1708
9
Lydia Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.10.6]
b. 24 Apr 1709
Hannah Haywood
b. 11 Mar 1689 d. Aft 1717
9
Benjamin Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.10.7]
b. 13 Jul 1713 d. 7 Jul 1739
9
Aaron Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.10.8]
b. 11 Nov 1715 d. 28 Apr 1785
Jemima Cook
b. 16 Nov 1716 d. 16 Oct 1815
10
Elisabeth Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.1]
b. 29 Oct 1740
10
Jemima Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.2]
b. 14 Sep 1742 d. 1764
10
Benjamin Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.3]
b. 16 Apr 1744 d. 29 Jun 1826
10
Susanna Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.4]
b. 23 Apr 1746 d. 4 Jan 1808
Henry Benson
b. 5 Dec 1743 d. 7 Dec 1777
11
Hannah Benson
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.4.1]
b. 7 May 1764
+
Aaron Legg
11
Joanna Benson
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.4.2]
b. 6 Jul 1766 d. 29 Dec 1820
Daniel Holbrook
b. 7 Feb 1765 d. 10 Jun 1831
12
Henry Benson Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.4.2.1]
b. 21 Aug 1788 d. 1870 [
=>
]
12
Marcus Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.4.2.2]
b. Abt 1791 d. Aft 1840
12
Lydia Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.4.2.3]
b. Abt 1793 d. 19 Feb 1820
12
Daniel Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.4.2.4]
b. 28 Feb 1796 d. 18 Oct 1864
12
Rufus Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.4.2.5]
b. Abt 1801 [
=>
]
12
Abraham Staples Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.4.2.6]
b. Abt 1806 d. 1 May 1862
12
Millins Holbrook
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.4.2.7]
b. Abt 1808 [
=>
]
11
Abigail Benson
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.4.3]
b. 2 Jul 1768
+
Henry Staples
11
Henry Staples Benson
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.4.4]
b. 8 Aug 1770 d. 29 Jul 1821
Lydia Sibley
b. 2 Apr 1769 d. 27 Nov 1822
12
Abigail Benson
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.4.4.1]
b. 31 Mar 1795 d. 10 Nov 1821 [
=>
]
12
Harriet Benson
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.4.4.2]
b. 14 Sep 1796 d. 22 Aug 1852
12
Mellen Benson
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.4.4.3]
b. 14 Jan 1798 [
=>
]
12
Hannah Adaline Benson
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.4.4.4]
b. 12 Aug 1802 d. 19 Jun 1822
12
Rufus Benson
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.4.4.5]
b. 24 Jan 1804 d. 23 Aug 1805
12
Chloe Ann Benson
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.4.4.6]
b. 23 Aug 1806
12
Susan Augusta Benson
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.4.4.7]
b. 9 Oct 1809 d. 25 Jul 1831 [
=>
]
12
Rufus Aldrich Benson
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.4.4.8]
b. 9 Oct 1809
12
Stephen Sibley Benson
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.4.4.9]
b. 9 Jan 1810 d. 20 Nov 1869 [
=>
]
11
Tirza Benson
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.4.5]
b. 29 Apr 1772
Wilder Johnson
b. 1768
12
Elmira Johnson
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.4.5.1]
b. 1810 d. 27 May 1816
11
Susanna Thayer Benson
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.4.6]
b. 19 Feb 1775
+
Gideon Angel
b. Abt 1770
11
Rachel Benson
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.4.7]
b. 5 May 1777 d. 21 Nov 1842
General Charles Jenckes
b. 7 Aug 1767 d. 4 Jul 1838
12
Charles Benson Jenckes
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.4.7.1]
b. 10 Apr 1796 d. Aft 1831 [
=>
]
10
Rachel Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.5]
b. 26 Mar 1748 d. 4 Jan 1802
10
Joanna Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.6]
b. 16 Feb 1750
10
Urana Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.7]
b. 12 Aug 1752 d. 19 Feb 1821
10
Elona Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.8]
b. 19 May 1754
10
Lavina Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.9]
b. 30 Jan 1756
10
Aaron Thayer, Jr
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.10]
b. 26 Feb 1758 d. 9 Oct 1829
10
Elijah Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.11]
b. 12 Aug 1760 d. 20 Sep 1764
10
Phebe Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.12]
b. 17 Aug 1762 d. 1840
10
Hannah Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.13]
b. Abt 1744
Pelatiah Thayer
b. 13 Oct 1739 d. 23 Mar 1797
11
Robert Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.13.1]
b. 22 Nov 1763 d. 1830
11
Artemas Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.13.2]
b. 20 Feb 1765 d. 1849
11
Henry Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.13.3]
b. 19 Sep 1768 d. 1776
11
Smith P Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.13.4]
b. 15 Dec 1770 d. 31 Mar 1818
11
Lavon Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.13.5]
b. 14 Mar 1773
11
Laban Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.13.6]
b. 19 Mar 1773 d. 1792
11
Putman Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.13.7]
b. 15 Aug 1774 d. 14 Nov 1776
11
Henry Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.13.8]
b. 3 Nov 1777 d. 7 Jul 1824
Urana Thompson
b. Abt 1778 d. 1859
12
Urana Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.13.8.1]
b. 26 Dec 1801 d. 15 Nov 1822 [
=>
]
12
Sarah Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.13.8.2]
b. 1802 d. 23 Jul 1847
12
Alice Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.13.8.3]
b. 1 Dec 1803 d. 29 Mar 1825
12
Betsey Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.13.8.4]
b. 6 Mar 1806 d. 9 Mar 1809
12
Preserved Smith Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.13.8.5]
b. 9 May 1808 [
=>
]
12
Henry Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.13.8.6]
b. 9 Oct 1810
12
Nancy Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.13.8.7]
b. 16 Oct 1815 d. 27 May 1831
12
Harriet Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.13.8.8]
b. 7 Feb 1819
12
Hannah Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.13.8.9]
b. 11 Feb 1820 [
=>
]
12
Edward Davis Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.13.8.10]
b. 22 Jul 1822 d. 12 May 1903
11
Mary Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.13.9]
b. 3 Nov 1777
11
John Thayer
[1.3.3.1.1.3.4.10.8.13.10]
b. 20 Feb 1784 d. 5 Nov 1829
7
Ursula Thayer
[1.3.3.1.1.3.5]
b. 8 Oct 1626 d. 2 May 1627
7
Shadrach Thayer
[1.3.3.1.1.3.6]
b. 10 May 1629 d. 19 Oct 1678
Mary Barrett
b. Abt 1633 d. 2 Feb 1657
8
Rachel Thayer
[1.3.3.1.1.3.6.1]
b. 9 Nov 1655 d. 23 Nov 1656
8
Tryall Thayer
[1.3.3.1.1.3.6.2]
b. 12 Jul 1657 d. 1 Jan 1738
8
Ephraim Thayer
[1.3.3.1.1.3.6.3]
b. 17 Nov 1669 d. 15 Jun 1757
8
Freelove Thayer
[1.3.3.1.1.3.6.4]
b. 1658 d. 5 Aug 1662
8
Joanna Thayer
[1.3.3.1.1.3.6.5]
b. 13 Dec 1665
8
Hannah Thayer
[1.3.3.1.1.3.6.6]
b. Abt 1663 d. 5 Feb 1673
8
Mary Thayer
[1.3.3.1.1.3.6.7]
b. 1 Oct 1663 d. 29 Sep 1713
8
William Thayer
[1.3.3.1.1.3.6.8]
b. 1 Aug 1675 d. 5 May 1727
8
Samuel Thayer
[1.3.3.1.1.3.6.9]
b. 7 Jul 1667 d. 1710
+
Deliverance Priest
b. 1635 d. 17 Jan 1723
7
Mary Thayer
[1.3.3.1.1.3.7]
b. 24 Jun 1630
7
Daughter Thayer
[1.3.3.1.1.3.8]
b. Dec 1632 bur. 1632
7
Elizabeth Thayer
[1.3.3.1.1.3.9]
b. 12 Apr 1635
7
Hannah Thayer
[1.3.3.1.1.3.10]
b. Abt 1636 d. 1672
Samuel Hayden
b. 1638 d. 1676
8
Sarah Hayden
[1.3.3.1.1.3.10.1]
b. 25 Jun 1668
8
Suasnna Hayden
[1.3.3.1.1.3.10.2]
b. 1666 d. Bef 1750
8
Catharine Hayden
[1.3.3.1.1.3.10.3]
b. 10 Jan 1670 d. 14 May 1730
8
Samuel Hayden
[1.3.3.1.1.3.10.4]
b. 17 Jun 1673 d. Bef 17 Jun 1677
7
Jonathan Thayer
[1.3.3.1.1.3.11]
c. 27 Dec 1637
7
Sarah Thayer
[1.3.3.1.1.3.12]
b. 1639 d. 27 Aug 1695
+
Jonathan Hayward
b. 1641 d. 21 Nov 1689
7
Ruth Thayer
[1.3.3.1.1.3.13]
b. Abt 1641 d. Abt 1691
6
Sicely Thayer
[1.3.3.1.1.4]
b. 1 May 1600 d. 28 May 1673
6
Richard Thayer, Jr
[1.3.3.1.1.5]
b. 5 Apr 1601 d. 8 Oct 1664
6
Catherine Thayer
[1.3.3.1.1.6]
b. 24 Feb 1603 d. 4 Jul 1631
6
Margaret Thayer
[1.3.3.1.1.7]
b. 10 Jun 1606 d. 1632
6
Ann Agnes Thayer
[1.3.3.1.1.8]
b. 15 Mar 1607 d. 27 Jun 1683
6
John Thayer
[1.3.3.1.1.9]
b. 29 Apr 1610 d. 12 Oct 1610
6
John Thayer
[1.3.3.1.1.10]
b. 26 Dec 1611 d. 20 Feb 1627
5
Margery Dimery
[1.3.3.1.2]
b. Abt 1565
5
Ruth Dimery
[1.3.3.1.3]
b. 15 Jan 1567
5
John Dymery
[1.3.3.1.4]
b. Abt 1570
5
Robert Dimery
[1.3.3.1.5]
c. 4 Jan 1572
5
Alyce Dymery
[1.3.3.1.6]
c. 16 Feb 1578
4
John Gould
[1.3.3.2]
b. 1534
4
William Gould
[1.3.3.3]
b. 1536
4
Eleanor Gould
[1.3.3.4]
b. 1538
4
Alice Gould
[1.3.3.5]
b. 1545
4
Katherine Gould
[1.3.3.6]
b. 1550
3
John Gould
[1.3.4]
b. Abt 1513 d. 2 Mar 1562
3
Agnes Gould
[1.3.5]
b. Abt 1515 d. 13 Aug 1558
3
James Gould
[1.3.6]
b. 1517 d. 13 Aug 1558
3
Edward Gould
[1.3.7]
b. Abt 1519