Home Page
|
What's New
|
Photos
|
Histories
|
Headstones
|
Reports
|
Surnames
Search
First Name:
Last Name:
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Suomalainen
Svenska
Robert Redmayne Parker
1528 - 1548 (20 years)
Submit Photo / Document
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Submit Photo / Doc
Worksheet
Family
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Robert Redmayne Parker
[1]
b. 1528 d. 28 Sep 1548
Elizabeth Chadderton
b. 1536 d. Bef 1646
2
Edmond Parker
[1.1]
b. 1555 d. Abt 1575
2
Robert Parker
[1.2]
b. 1556 d. 1614
Mary Eydith Burge
b. 1555 d. 10 Oct 1649
3
Robert Parker
[1.2.1]
b. 1569 d. 1614
Dorothy Stevens
b. Abt 1569 d. 11 Apr 1650
4
Sarah Parker
[1.2.1.1]
b. 15 Apr 1583 d. 9 Dec 1637
+
Thomas Bailey
b. 1578 d. Bef 1680
Reverend John Woodbridge
b. Abt 1582 d. 9 Dec 1637
5
Reverend John Woodbridge
[1.2.1.1.1]
b. 1613 d. 17 Mar 1696
5
Sarah Woodbridge
[1.2.1.1.2]
b. 1614
5
Tymothie Woodbridge
[1.2.1.1.3]
b. 1614 d. Bef 1649
5
Hester Woodbridge
[1.2.1.1.4]
b. Abt 1618 d. Bef 1649
5
Reverend Benjamin Woodbridge
[1.2.1.1.5]
b. 1622 d. 1 Nov 1684
5
Lucy Woodbridge
[1.2.1.1.6]
b. Apr 1623
4
Elizabeth Parker
[1.2.1.2]
b. 1590 d. 1653
4
Thomas Parker
[1.2.1.3]
d. 24 Apr 1677
3
Richard Parker
[1.2.2]
b. Abt 1572 d. 8 Jul 1636
+
Mary Baiford
b. Abt 1576
3
Anne Parker
[1.2.3]
b. Jun 1575 d. 7 Mar 1657
Richard Noyes
b. 1565 d. 25 Aug 1639
4
Peter Noyes
[1.2.3.1]
b. 1591 d. 23 Sep 1657
4
Elizabeth Noyes
[1.2.3.2]
b. 1610 d. Bef 1698
Thomas Hapgood
b. 1601 d. 1666
5
John Hapgood
[1.2.3.2.1]
b. 2 Apr 1632
Joan Blake
b. Abt 1636
6
John Hapgood
[1.2.3.2.1.1]
b. 2 Feb 1664
Elizabeth Dear
7
William Hopgood
[1.2.3.2.1.1.1]
b. 27 Jul 1702
7
Joan Hopgood
[1.2.3.2.1.1.2]
b. 14 May 1705
Robert White
b. 17 Jun 1700
8
William White
[1.2.3.2.1.1.2.1]
b. 1730
Elizabeth Futcher
b. 5 Mar 1741 d. 1775
9
William White
[1.2.3.2.1.1.2.1.1]
c. 9 Feb 1759 d. 1803
Elizabeth Greenwood
b. 1763 d. 26 Jul 1844
10
James White
[1.2.3.2.1.1.2.1.1.1]
b. 8 Aug 1787 d. 2 Oct 1867
Charlotte Newington
b. 22 Nov 1789 d. 14 Aug 1820
11
Mary Ann White
[1.2.3.2.1.1.2.1.1.1.1]
b. 9 May 1815 d. Abt 1845
William Pay
b. 1811
12
Reuben Pay
[1.2.3.2.1.1.2.1.1.1.1.1]
b. 1838
12
Ann Pay
[1.2.3.2.1.1.2.1.1.1.1.2]
b. 1839
12
Robert Pay
[1.2.3.2.1.1.2.1.1.1.1.3]
b. 1841 d. 16 Jun 1841
12
John Pay
[1.2.3.2.1.1.2.1.1.1.1.4]
b. Abt 1842
12
David Pay
[1.2.3.2.1.1.2.1.1.1.1.5]
b. Abt 1845
12
Elizabeth Pay
[1.2.3.2.1.1.2.1.1.1.1.6]
b. Jul 1847 d. 1908
12
Joseph Pay
[1.2.3.2.1.1.2.1.1.1.1.7]
b. 1850
12
Rose Pay
[1.2.3.2.1.1.2.1.1.1.1.8]
b. Abt 1854
12
Mercey Pay
[1.2.3.2.1.1.2.1.1.1.1.9]
b. Sep 1854
12
Rhoda Pay
[1.2.3.2.1.1.2.1.1.1.1.10]
b. 1856 d. 27 Jan 1934
11
George White
[1.2.3.2.1.1.2.1.1.1.2]
b. 20 Jul 1817 d. 26 Jan 1861
11
James White
[1.2.3.2.1.1.2.1.1.1.3]
b. 3 Apr 1818 d. 12 Feb 1869
Martha Chessel
b. 13 Jan 1825 d. 18 Jan 1870
12
Elizabeth Chessel White
[1.2.3.2.1.1.2.1.1.1.3.1]
b. 17 May 1847 d. 23 Jun 1868
12
Charlotte Chessel White
[1.2.3.2.1.1.2.1.1.1.3.2]
b. 22 Sep 1848 d. 21 Aug 1926 [
=>
]
12
Charles William Chessel White
[1.2.3.2.1.1.2.1.1.1.3.3]
b. 20 Feb 1851 d. 25 Aug 1924 [
=>
]
12
George Chessel White
[1.2.3.2.1.1.2.1.1.1.3.4]
b. 7 Feb 1854 d. 6 Feb 1922 [
=>
]
12
Susan Chessel White
[1.2.3.2.1.1.2.1.1.1.3.5]
b. 11 Jul 1857 d. 30 Oct 1942 [
=>
]
12
Alice Mary White
[1.2.3.2.1.1.2.1.1.1.3.6]
b. 13 May 1860 d. 25 May 1909 [
=>
]
Mary Newington
b. Jul 1800 bur. 16 Jan 1871
11
Henry White
[1.2.3.2.1.1.2.1.1.1.4]
b. 18 Jan 1823
11
William White
[1.2.3.2.1.1.2.1.1.1.5]
b. 1826 d. Jul 1871
11
Harriet White
[1.2.3.2.1.1.2.1.1.1.6]
b. 2 Jul 1828
11
Charles White
[1.2.3.2.1.1.2.1.1.1.7]
b. 1831
11
Thomas Richard White
[1.2.3.2.1.1.2.1.1.1.8]
b. 17 Feb 1833 bur. 4 Apr 1869
7
Ann Hopgood
[1.2.3.2.1.1.3]
c. 5 May 1697
6
Elizabeth Hapgood
[1.2.3.2.1.2]
b. Abt 1659
6
Mary Hapgood
[1.2.3.2.1.3]
b. Abt 1661
6
Elinor Hapgood
[1.2.3.2.1.4]
b. Abt 1663
5
Nathaniel Hapgood
[1.2.3.2.2]
b. Bef 1638
5
Thomas Hapgood
[1.2.3.2.3]
b. Bef 1640
5
Shadrack Hapgood
[1.2.3.2.4]
b. Abt 1642 d. 2 Aug 1675
Elizabeth Treadway
b. 3 Aug 1646 d. 18 Sep 1714
6
Nathaniel Hapgood
[1.2.3.2.4.1]
b. 21 Oct 1665 d. 3 Dec 1727
Elizabeth Ward
b. 21 Mar 1672 d. 5 Nov 1748
7
Nathaniel Hapgood
[1.2.3.2.4.1.1]
b. Abt 1696 d. Abt 1746
7
Shadrach Hapgood
[1.2.3.2.4.1.2]
b. Abt 1702 d. 13 May 1768
Elizabeth Wetherbee
b. 21 Apr 1715 d. 30 Nov 1808
8
Mary Mercy Hapgood
[1.2.3.2.4.1.2.1]
b. 26 Jan 1732 d. 23 Oct 1815
8
Elizabeth Hapgood
[1.2.3.2.4.1.2.2]
b. 26 Sep 1734 d. 13 Nov 1803
8
Phineas Hapgood
[1.2.3.2.4.1.2.3]
b. 1737 d. Aug 1737
8
Asa Hapgood
[1.2.3.2.4.1.2.4]
b. 1739 d. 16 Aug 1743
8
Israel Hapgood
[1.2.3.2.4.1.2.5]
b. 1741 d. 2 Mar 1743
8
Sarah Hopgood
[1.2.3.2.4.1.2.6]
b. 16 Jun 1744
John Daby
b. Abt 1724
9
Simon Daby
[1.2.3.2.4.1.2.6.1]
b. 20 Mar 1765 d. 18 Dec 1802
9
Asa Daby
[1.2.3.2.4.1.2.6.2]
b. 3 Feb 1767 d. 10 Aug 1813
9
Mercy Daby
[1.2.3.2.4.1.2.6.3]
b. 11 May 1769
9
Sarah Daby
[1.2.3.2.4.1.2.6.4]
b. 7 Feb 1772
Josiah Stone
b. 1 Apr 1771
10
Josiah Stone
[1.2.3.2.4.1.2.6.4.1]
b. 29 Dec 1797
10
Levi Stone
[1.2.3.2.4.1.2.6.4.2]
b. 5 Sep 1799
10
Ezra Stone
[1.2.3.2.4.1.2.6.4.3]
b. 8 Dec 1801
10
Sarah Stone
[1.2.3.2.4.1.2.6.4.4]
b. 21 Apr 1805 d. 1849
Lucius Augustus Bingham
b. 1 Sep 1804
11
Calvin Bingham
[1.2.3.2.4.1.2.6.4.4.1]
b. 7 Sep 1827 d. 27 May 1883
11
Benjamin Bingham
[1.2.3.2.4.1.2.6.4.4.2]
b. 1829 d. 27 May 1883
11
Augustus Bingham
[1.2.3.2.4.1.2.6.4.4.3]
b. 27 Oct 1831 d. 20 May 1908
11
Levi Perry Bingham
[1.2.3.2.4.1.2.6.4.4.4]
b. 5 Nov 1832 d. 9 Oct 1903
Sarah Ann Elizabeth Lusk
b. 21 Nov 1833 d. 28 Apr 1893
12
Louisa Elizabeth Bingham
[1.2.3.2.4.1.2.6.4.4.4.1]
b. 22 Jun 1853 d. 7 Feb 1935
12
Susan Emaline Bingham
[1.2.3.2.4.1.2.6.4.4.4.2]
b. 16 Jun 1855 d. 26 Mar 1935
12
Perry Calvin Bingham
[1.2.3.2.4.1.2.6.4.4.4.3]
b. 29 Jun 1857 d. 17 Jul 1916 [
=>
]
12
John Samuel Bingham
[1.2.3.2.4.1.2.6.4.4.4.4]
b. 23 Feb 1860 d. 6 Sep 1927
12
Lucius Augustus Bingham
[1.2.3.2.4.1.2.6.4.4.4.5]
b. 5 Apr 1862 d. 16 Jan 1931
12
Lucy Lucretia Bingham
[1.2.3.2.4.1.2.6.4.4.4.6]
b. 28 Jun 1864 d. 2 Jul 1917
12
Sarah Maria Bingham
[1.2.3.2.4.1.2.6.4.4.4.7]
b. 8 Apr 1867 d. 16 Apr 1936
12
William David Bingham
[1.2.3.2.4.1.2.6.4.4.4.8]
b. 8 Jun 1870 d. 6 Sep 1899
12
Mary Ardella Bingham
[1.2.3.2.4.1.2.6.4.4.4.9]
b. 21 Sep 1874 d. 7 Dec 1915
11
Son Bingham
[1.2.3.2.4.1.2.6.4.4.5]
b. 10 May 1834 d. Abt 1835
11
Mary Emiline Bingham
[1.2.3.2.4.1.2.6.4.4.6]
b. 10 May 1834 d. 1874
11
Prosper Bingham
[1.2.3.2.4.1.2.6.4.4.7]
b. 1840 d. Abt 1845
11
Lucy Bingham
[1.2.3.2.4.1.2.6.4.4.8]
b. 1843
9
Betsey Daby
[1.2.3.2.4.1.2.6.5]
b. 7 Mar 1774
9
John Daby
[1.2.3.2.4.1.2.6.6]
b. 9 Jan 1779 d. 16 May 1789
8
Shadrach Hapgood
[1.2.3.2.4.1.2.7]
b. 1745 d. 20 Jan 1818
8
Oliver Hapgood
[1.2.3.2.4.1.2.8]
b. 1747 d. 7 Oct 1751
8
Lydia Hapgood
[1.2.3.2.4.1.2.9]
b. Abt 1751 d. 16 Dec 1834
7
Deacon Daniel Hapgood
[1.2.3.2.4.1.3]
b. 1706 d. 30 Apr 1791
7
Sarah Hapgood
[1.2.3.2.4.1.4]
b. Abt 1708
6
Mary Habgood
[1.2.3.2.4.2]
b. 2 Nov 1667 d. 13 Jan 1692
6
Thomas Hapgood
[1.2.3.2.4.3]
b. 1 Feb 1669 d. 4 Oct 1764
6
Sarah Hapgood
[1.2.3.2.4.4]
b. 1672 d. Aft 1730
6
Elizabeth Hapgood
[1.2.3.2.4.5]
b. 1674 d. 20 Jul 1689
Reverend William Noyes
b. 1568 d. 30 Apr 1622
4
Ephraim Noyes
[1.2.3.3]
b. 1596 d. 28 Oct 1659
+
Parnell Brewer
b. 1597 d. Abt 1659
4
Reverend Nathan Noyes
[1.2.3.4]
b. 15 May 1597 d. 6 Sep 1651
Mary Parker
b. Abt 1602 d. 1657
5
Abigail Noyes
[1.2.3.4.1]
b. Abt 1630
5
Elizabeth Noyes
[1.2.3.4.2]
b. Abt 1628
5
Nathan Noyes
[1.2.3.4.3]
b. Abt 1622
5
Marie Noyes
[1.2.3.4.4]
b. Abt 1626
5
Rachel Noyes
[1.2.3.4.5]
b. Aft 1630 d. 1651
4
Sarah Noyes
[1.2.3.5]
b. Abt 1602 d. 16 Oct 1671
4
Reverend James Noyes
[1.2.3.6]
b. 22 Oct 1608 d. 22 Oct 1656
Sarah Browne
b. 1610 d. 13 Sep 1691
5
Joseph Noyes
[1.2.3.6.1]
b. 15 Oct 1637 d. 16 Nov 1717
Mary Darvell
b. 10 May 1642 d. 24 Sep 1677
6
Joseph Noyes
[1.2.3.6.1.1]
b. 16 Aug 1663
6
Sarah Noyes
[1.2.3.6.1.2]
b. 28 Sep 1669 d. Sep 1756
6
Rebecca Noyes
[1.2.3.6.1.3]
b. 22 Sep 1671 d. 17 Nov 1734
6
Moses Noyes
[1.2.3.6.1.4]
b. 9 Sep 1667 d. 19 May 1689
6
Thomas Noyes
[1.2.3.6.1.5]
b. 13 Sep 1667 d. 13 Sep 1667
6
Mary Noyes
[1.2.3.6.1.6]
b. 22 Jun 1666 d. 11 Jan 1743
6
Lieutenant John Noyes
[1.2.3.6.1.7]
b. 9 Mar 1674 d. 15 Apr 1765
5
Reverend James Noyes
[1.2.3.6.2]
b. 11 Mar 1640 d. 30 Dec 1719
Dorothy Stanton
b. Abt 1650 d. 19 Jan 1742
6
John Noyes
[1.2.3.6.2.1]
b. 13 Jan 1685 d. 17 Sep 1751
6
Joseph Noyes
[1.2.3.6.2.2]
b. 16 Oct 1688 d. 14 Jun 1761
6
Moses Noyes
[1.2.3.6.2.3]
b. 19 Mar 1692 d. 30 Apr 1692
6
Dorothy Noyes
[1.2.3.6.2.4]
b. 20 Jan 1676 d. 6 Dec 1714
6
Anna Noyes
[1.2.3.6.2.5]
b. 16 Apr 1682 d. 28 Jun 1694
6
James Noyes
[1.2.3.6.2.6]
c. 21 Oct 1677 bur. 1718
6
Thomas Noyes
[1.2.3.6.2.7]
b. 15 Aug 1679 d. 26 Jun 1755
5
Reverend Moses Noyes
[1.2.3.6.3]
b. 23 Sep 1648 d. 25 Oct 1734
Ruth Pickett
b. 16 Dec 1653 d. 14 Sep 1690
6
Naomi Noyes
[1.2.3.6.3.1]
b. Abt 1676 d. 15 Mar 1728
William Comstock
b. 8 Jan 1669 d. 15 Mar 1728
7
John Comstock
[1.2.3.6.3.1.1]
b. 9 Aug 1696 d. 28 Mar 1767
Rebecca Bates
b. Abt 1704
8
Phebe Comstock
[1.2.3.6.3.1.1.1]
b. 16 Nov 1727
8
Curtis Comstock
[1.2.3.6.3.1.1.2]
b. 8 Oct 1729 d. 1772
8
Rebecca Comstock
[1.2.3.6.3.1.1.3]
b. 11 Feb 1732
8
Gideon Comstock
[1.2.3.6.3.1.1.4]
b. Abt 1736 d. 1746
7
William Comstock
[1.2.3.6.3.1.2]
b. 15 Jun 1698 d. 19 Jun 1765
Mary Bates
b. 1 Jul 1711 d. 29 Mar 1743
8
Abigail Comstock
[1.2.3.6.3.1.2.1]
c. 27 Apr 1726 d. 1776
8
William Comstock
[1.2.3.6.3.1.2.2]
b. 1733 d. 1773
8
Anne Comstock
[1.2.3.6.3.1.2.3]
b. Abt 1737
8
Naomi Comstock
[1.2.3.6.3.1.2.4]
b. 1739 d. 21 Dec 1831
8
Ruth Comstock
[1.2.3.6.3.1.2.5]
b. 18 Apr 1741 d. 18 Apr 1804
7
Abigail Comstock
[1.2.3.6.3.1.3]
b. 1700 d. 16 Oct 1773
Joseph Lord
b. 17 Oct 1697 d. 25 Jul 1736
8
Abigail Lord
[1.2.3.6.3.1.3.1]
b. 3 Feb 1726 d. 1771
8
Joseph Lord
[1.2.3.6.3.1.3.2]
b. 3 Feb 1726 d. 13 Mar 1788
8
Benjamin Lord
[1.2.3.6.3.1.3.3]
b. 3 Jan 1728 d. 6 Feb 1805
8
Elijah Lord
[1.2.3.6.3.1.3.4]
b. 1 Jan 1730
8
Elizabeth Lord
[1.2.3.6.3.1.3.5]
b. 19 Aug 1732 d. 20 Dec 1753
8
Sylvanus Lord
[1.2.3.6.3.1.3.6]
b. 21 Aug 1734 d. 29 Nov 1762
8
Captain Daniel Lord
[1.2.3.6.3.1.3.7]
b. 1736 d. 21 Sep 1796
7
Ruth Comstock
[1.2.3.6.3.1.4]
b. Abt 1702
+
Jonathan Reed
b. 15 Apr 1686
7
Elizabeth Comstock
[1.2.3.6.3.1.5]
b. Abt 1704
+
McCrary
b. 1702
7
Phoebe Comstock
[1.2.3.6.3.1.6]
b. 1706 d. 1 Dec 1790
Lemuel Griffin
b. 23 Mar 1706 d. 15 Aug 1788
8
George Griffin
[1.2.3.6.3.1.6.1]
b. 10 Jul 1734 d. 6 Aug 1814
8
Lemuel Griffin
[1.2.3.6.3.1.6.2]
b. Abt 1736 d. 9 Jul 1810
8
Josiah Griffen
[1.2.3.6.3.1.6.3]
b. 21 Jul 1743
7
Naomi Comstock
[1.2.3.6.3.1.7]
b. 1708 d. 29 May 1743
Consider Tiffany
b. 28 Apr 1703 d. 29 May 1763
8
Consider Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.1]
b. 15 Mar 1732 d. 19 Jun 1796
Sarah Wilder
b. 13 Aug 1738 d. 7 Nov 1818
9
Jemima Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.1.1]
b. 12 Oct 1756 d. 24 Jul 1784
9
Ephriam Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.1.2]
b. 8 Nov 1758 d. 7 Apr 1818
9
Dorothy Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.1.3]
b. 19 Jun 1762 d. 7 Nov 1818
9
Levi Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.1.4]
b. 23 Apr 1766 d. 20 Nov 1851
9
Consider Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.1.5]
b. 12 Mar 1769 d. 4 Sep 1859
9
Betty Wilder Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.1.6]
b. 25 Feb 1772 d. 16 Feb 1837
9
Mary Willey Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.1.7]
b. 1 Apr 1775
9
Lewis Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.1.8]
b. Abt 1777 d. 13 Nov 1777
9
Dolly Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.1.9]
b. Abt 1779
8
Luther Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.2]
b. 15 Apr 1734
8
Naomi Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.3]
b. 28 Dec 1737 d. 25 Jul 1821
Ezekial Huntley
b. 9 Mar 1728 d. 25 Jul 1783
9
Rufus Huntley
[1.2.3.6.3.1.7.3.1]
b. 18 Sep 1764 d. 4 Apr 1860
9
Lois Huntley
[1.2.3.6.3.1.7.3.2]
b. 18 Sep 1764 d. 2 Feb 1848
9
Elias Huntley
[1.2.3.6.3.1.7.3.3]
b. 28 Jul 1765 d. 10 Jan 1783
9
Asher Hulbert
[1.2.3.6.3.1.7.3.4]
b. 1 Mar 1767 d. 1 Mar 1849
9
Naomi Huntley
[1.2.3.6.3.1.7.3.5]
b. Abt 1768 d. 2 Dec 1840
9
Ezra Huntley
[1.2.3.6.3.1.7.3.6]
b. 2 Jun 1771 d. 13 Apr 1817
9
Ezekiel Huntley, Jr
[1.2.3.6.3.1.7.3.7]
b. 21 May 1780 d. 5 Mar 1853
8
Samuel Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4]
b. 13 Jul 1740 d. Mar 1822
Abigail Curtis
b. 17 Mar 1742 d. May 1820
9
Samuel Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.1]
b. 21 Oct 1761 d. 21 Apr 1851
Mary Sackett
b. Abt 1761 d. 1862
10
Samuel Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.1.1]
b. 1788 d. Abt 1845
10
Mary Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.1.2]
b. 1797
10
Julia Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.1.3]
b. 1799 d. 13 Jan 1891
10
Thomas Jefferson Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.1.4]
b. 1801
10
Hannah Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.1.5]
b. 5 Apr 1804 d. 10 Sep 1860
10
Calinda Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.1.6]
b. 2 Dec 1807 d. 5 Mar 1866
10
Ezekiel Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.1.7]
b. 1810
10
Jefferson Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.1.8]
b. Abt 1810
10
Harry Edward Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.1.9]
b. 25 Jun 1813 d. 14 Dec 1871
10
Harriet Emeline Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.1.10]
b. Abt 1815
10
Lorenzo Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.1.11]
b. Abt 1818
9
Nathanial Curtis Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.2]
b. 18 Feb 1762 d. 13 Feb 1857
Dency Crane
b. Abt 1765
10
Nathaniel Curtis Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.2.1]
b. Mar 1790
10
Harriet Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.2.2]
b. Mar 1792 d. 1858
10
Dancy Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.2.3]
b. 25 Sep 1795 d. 24 Mar 1846
10
Anron Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.2.4]
b. 2 Jun 1797 d. 27 Feb 1847
10
Betsey Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.2.5]
b. Abt 1799
10
David Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.2.6]
b. 1800
10
Mary Polly Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.2.7]
b. 17 Dec 1801 d. 20 May 1835
10
Elizabeth Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.2.8]
b. 1805
10
Caroline Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.2.9]
b. Abt 1807 d. 1843
9
Jemima Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.3]
b. 1763 d. 6 Mar 1848
Reuben Ward
b. 13 Nov 1748 d. 5 Jul 1825
10
Affa Ward
[1.2.3.6.3.1.7.4.3.1]
b. 27 May 1783 d. 28 Feb 1877
William Stilson
b. 23 Sep 1783 d. 4 May 1862
11
Caroline Stilson
[1.2.3.6.3.1.7.4.3.1.1]
b. 20 Jan 1808 d. 12 Jan 1883
11
Albert Stilson
[1.2.3.6.3.1.7.4.3.1.2]
b. 16 Jan 1810 d. 30 Sep 1895
11
Celinda Stilson
[1.2.3.6.3.1.7.4.3.1.3]
b. 4 Feb 1811 d. 26 Jun 1845
11
Emeline Stilson
[1.2.3.6.3.1.7.4.3.1.4]
b. 27 Sep 1813 d. 6 Jan 1887
11
William M Stilson
[1.2.3.6.3.1.7.4.3.1.5]
b. 2 Apr 1816
11
Saphronia Stilson
[1.2.3.6.3.1.7.4.3.1.6]
b. 3 Nov 1817 d. 6 Jan 1887
11
Minor Stilson
[1.2.3.6.3.1.7.4.3.1.7]
b. 9 Jan 1821
11
Affa C Stilson
[1.2.3.6.3.1.7.4.3.1.8]
b. 31 Mar 1823 d. Abt 1879
11
Rueben R Stilson
[1.2.3.6.3.1.7.4.3.1.9]
b. 29 Dec 1824
11
Allen Stilson
[1.2.3.6.3.1.7.4.3.1.10]
b. 12 Apr 1827 d. 25 Jan 1878
10
Reuben Ward
[1.2.3.6.3.1.7.4.3.2]
b. Abt 1784 d. 5 Mar 1876
10
Jemima Ward
[1.2.3.6.3.1.7.4.3.3]
b. Abt 1786
10
Laura Ward
[1.2.3.6.3.1.7.4.3.4]
b. Abt 1790
10
Eda Ward
[1.2.3.6.3.1.7.4.3.5]
b. Abt 1788
10
Samuel Ward
[1.2.3.6.3.1.7.4.3.6]
b. Abt 1792 d. 23 Feb 1873
10
Dorcas Ward
[1.2.3.6.3.1.7.4.3.7]
b. Abt 1794
10
Cynthia Ward
[1.2.3.6.3.1.7.4.3.8]
b. Abt 1796
+
Henry Rolluff
b. Abt 1782
10
William B Ward
[1.2.3.6.3.1.7.4.3.9]
b. 1801
10
Daniel Ward
[1.2.3.6.3.1.7.4.3.10]
b. 1807
9
William Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.4]
b. Abt 1765
9
Emellason Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.5]
b. Abt 1765 d. 18 Mar 1847
Sarah Aldrich
b. 4 Apr 1773
10
Rhoda Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.5.1]
b. 1 Nov 1793
10
George Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.5.2]
b. 5 May 1794
10
Lemuel Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.5.3]
b. 30 Jun 1796
10
David Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.5.4]
b. 18 Aug 1798
10
Sarah Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.5.5]
b. 27 Mar 1803 d. 14 Nov 1838
10
Silas Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.5.6]
b. 13 Apr 1809
9
Daniel Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.6]
b. 18 Sep 1768 d. 25 Sep 1793
+
Phebe Rand
b. Abt 1770
9
Abigail Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.7]
b. Abt 1770
+
Zenos Aldrich
b. 1766 d. 8 Nov 1856
9
George Obediah Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.8]
b. 7 May 1772 d. 13 Feb 1857
Mary Mason
b. Abt 1766 d. 16 Mar 1840
10
Abigail Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.1]
b. Abt 1797 d. Dec 1859
10
Zilpha Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.2]
b. Abt 1799 d. 1830
10
Zenas Schovil Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.3]
b. 25 Jun 1801 d. 1822
10
Luther Little Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.4]
b. 28 Mar 1803 d. 17 Feb 1881
10
Frederick Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.5]
b. 1804 d. 1804
10
Lorenzo Mason Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.6]
b. Abt 1804 d. Abt 1809
10
Jane Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.7]
b. 14 Apr 1805 d. 26 Nov 1867
10
George Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.8]
b. 4 May 1808 d. 21 Jun 1885
Almira Whipple
b. 13 Jun 1810 d. 4 Feb 1889
11
Cynthia Jane Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.8.1]
b. 2 Feb 1830 d. 6 Oct 1845
11
Zenos Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.8.2]
b. 21 Jul 1831 d. Dec 1843
11
Ira Patchen Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.8.3]
b. 14 Feb 1835 d. 21 Mar 1905
Mary Ann Davis
b. 4 Oct 1843 d. 21 Jul 1885
12
Ira Davies Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.8.3.1]
b. 24 Jul 1863 d. 27 Oct 1902
12
Zenos William Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.8.3.2]
b. 21 Aug 1865 d. 14 Feb 1938
12
Sylvia Ann Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.8.3.3]
b. 14 Nov 1867 d. 23 Dec 1936
12
Cynthia Jane Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.8.3.4]
b. 27 Feb 1870 d. Bef 1877
12
Mary Elizabeth Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.8.3.5]
b. 17 May 1871 d. 5 Nov 1887
12
Almira Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.8.3.6]
b. 29 Dec 1873 d. 21 Sep 1887
12
Franklin Brayn Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.8.3.7]
b. 29 Feb 1876 d. 4 Oct 1877
12
Eliza Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.8.3.8]
b. 30 Jan 1878 d. 2 Jun 1957
12
George Hyrum Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.8.3.9]
b. 17 Apr 1880 d. 18 Mar 1939
12
Albert Henry Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.8.3.10]
b. 5 Nov 1882 d. 2 Dec 1956
12
Ray Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.8.3.11]
b. 21 Jul 1884 d. 16 Oct 1885
+
Sarah Ann Jolley
b. 18 Dec 1837 d. 9 Jan 1919
11
Loyal Peck Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.8.4]
b. 27 Jul 1837 d. 15 Feb 1903
+
Martha Holden
b. 28 Jan 1825 d. 3 May 1886
11
Mary Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.8.5]
b. 18 Dec 1844 d. 14 Dec 1845
11
Almira Rebecca Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.8.6]
b. 18 Aug 1847 d. 23 Nov 1914
Giles Bliss Holden
b. 8 May 1842 d. 20 May 1897
12
Almira Rebecca Holden
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.8.6.1]
b. 8 Aug 1865 d. 25 Aug 1865
12
Ruia Angeline Holden
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.8.6.2]
b. 21 Oct 1866 d. 4 Mar 1948
12
Giles Robert Holden
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.8.6.3]
b. 8 Dec 1868 d. Mar 1889
12
Cynthia Holden
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.8.6.4]
b. 10 Mar 1870 d. 10 Mar 1870
12
George Tiffany Holden
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.8.6.5]
b. 9 May 1872 d. 13 Apr 1934
12
Nellie May Holden
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.8.6.6]
b. 30 Dec 1875 d. 6 Nov 1935
12
Burrell Henry Holden
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.8.6.7]
b. 29 Jun 1877 d. 11 Mar 1881
12
Leroy Edwin Holden
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.8.6.8]
b. 21 Sep 1879 d. 12 Feb 1881
12
Ivy LeNore Holden
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.8.6.9]
b. 24 May 1882 d. 18 Aug 1958
12
Merle Dee Holden
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.8.6.10]
b. 10 Jul 1885 d. 12 Sep 1938
12
Verna Holden
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.8.6.11]
b. 18 Dec 1887 d. 18 Dec 1887
12
Vera Holden
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.8.6.12]
b. 18 Dec 1887 d. 12 Feb 1967 [
=>
]
11
George Mason Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.8.7]
b. 31 Jan 1850 d. 14 Mar 1909
Sarah Jane York
b. 18 Feb 1857 d. 27 Dec 1940
12
Mary Ellen Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.8.7.1]
b. 22 Aug 1874 d. 18 Jun 1958
12
Sarah Jane Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.8.7.2]
b. 16 Apr 1876 d. 23 Apr 1883
12
George Mason Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.8.7.3]
b. 17 Nov 1877 d. 21 Apr 1883
12
Asa York Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.8.7.4]
b. 24 Feb 1881 d. 3 Feb 1947
12
Lea Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.8.7.5]
b. 7 May 1883 d. 7 Jan 1961
12
Ira George Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.8.7.6]
b. 7 May 1883 d. 7 Jan 1961
12
Nelson Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.8.7.7]
b. 4 Aug 1885 d. 27 Mar 1943
12
Almira Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.8.7.8]
b. 16 Sep 1888 d. 26 Jul 1966
12
Ruia Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.8.7.9]
b. 27 Nov 1890 d. 15 May 1965
12
Lenore Henrietta Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.8.7.10]
b. 9 Aug 1893 d. 11 Sep 1967
11
Nelson Whipple Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.8.8]
b. 6 Aug 1852 d. 20 Jan 1927
Nancy Medora Beesley
b. 8 Sep 1862 d. 15 May 1924
12
Nelson Whipple Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.8.8.1]
b. 11 Sep 1880 d. 20 Nov 1904
12
Florence Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.8.8.2]
b. 27 Apr 1882 d. 22 May 1964
12
Alathea Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.8.8.3]
b. 28 Aug 1884 d. 3 Jan 1897
12
Ida May Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.8.8.4]
b. 15 Nov 1888 d. 9 May 1968
12
George Milton Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.8.8.5]
b. 8 May 1892 d. 25 May 1963
12
Martha Elva Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.8.8.6]
b. 1 Aug 1898 d. 25 Nov 1989
12
Viola Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.8.8.7]
b. 5 Jul 1903 d. 19 Jun 1969
10
Lorenzo Roderick Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.9]
b. 4 Jul 1810 d. Abt 1810
10
Richard Mason Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.10]
b. 4 Jul 1810 d. 1897
10
Daniel Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.11]
b. 12 Sep 1812 d. 25 Jan 1894
10
Mary Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.12]
b. 28 Mar 1814 d. 1899
10
Phebe Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.13]
b. 24 Oct 1817 d. 20 Feb 1850
10
Larena Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.14]
b. 1818 d. 1844
10
Ann Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.8.15]
b. 4 Jun 1822 d. 12 Sep 1893
9
Mary Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.9]
b. 17 Jun 1777 d. 12 Sep 1845
Daniel Whipple
b. 27 Aug 1779 d. 27 Sep 1839
10
Cynthia Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.1]
b. 15 Jan 1805 d. 1889
Ezra Gray
b. 1793 d. 1870
11
Hiram T Gray
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.1.1]
b. 25 Aug 1832 d. 30 Jun 1875
+
Caroline R Lane
b. 1839 d. 1902
11
Daniel William Gray
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.1.2]
b. 19 May 1834 d. 9 Dec 1890
Eliza Jane Ostrander
b. Abt 1840 d. 29 Oct 1861
12
William Delvin Grey
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.1.2.1]
b. 27 Feb 1859 d. 11 Aug 1949
12
Frank Gray
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.1.2.2]
b. Abt 1861
Sarah Ann Smith
b. 19 Dec 1851 d. 15 Jan 1941
12
Jennie Gray
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.1.2.3]
b. 3 May 1870 d. 5 Oct 1941
12
Nellie F Gray
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.1.2.4]
b. 2 Jul 1871 d. Aug 1883
12
Frank N Gray
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.1.2.5]
b. 3 Nov 1873
12
Mary Ellen Gray
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.1.2.6]
b. 27 Aug 1877 d. 23 Feb 1953
12
Carrie M Gray
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.1.2.7]
b. 8 Dec 1881 d. 12 Sep 1949
11
Daughter Gray
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.1.3]
b. 1834
11
Emily Jane Gray
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.1.4]
b. 14 Nov 1837 d. 13 Feb 1908
11
Betsey T Gray
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.1.5]
b. 1840
11
Mary M Gray
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.1.6]
b. 1844
11
George W Gray
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.1.7]
b. 1846 d. 4 Aug 1918
Sidney
b. Jan 1846
12
Ramond G Gray
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.1.7.1]
b. Apr 1869
12
Minnie M Gray
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.1.7.2]
b. May 1872 [
=>
]
12
Floyd Gray
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.1.7.3]
b. Sep 1874
12
Daisey M Gray
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.1.7.4]
b. Jun 1881
10
Samuel Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.2]
b. 21 Dec 1808 d. 9 Jan 1887
Phoebe Kingsbury
b. 14 Dec 1812 d. 24 Apr 1851
11
Sabrina Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.2.1]
b. 30 Mar 1832 d. 1920
+
Scudder Todd
b. 1831 d. 1901
11
George T Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.2.2]
b. 4 Dec 1833 d. 28 Aug 1868
11
Polly Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.2.3]
b. 4 Jun 1835 d. 24 Mar 1855
11
Daniel Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.2.4]
b. 21 Jun 1837
11
Margaret Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.2.5]
b. 18 Jun 1839 d. 8 Oct 1840
11
Mason Kingsbury Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.2.6]
b. 17 Feb 1842 d. 27 Mar 1919
Olive Amanda Kingsbury
b. 10 Dec 1844 d. 1924
12
Nelson E Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.2.6.1]
b. 1867 d. 1943
12
Ina Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.2.6.2]
b. Sep 1869
12
George W Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.2.6.3]
b. Jan 1872
12
Pearl O Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.2.6.4]
b. Jun 1884
11
Samuel Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.2.7]
b. 4 Mar 1844 d. May 1924
11
Hassett Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.2.8]
b. 20 Feb 1846 d. 3 Jan 1852
11
Almira Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.2.9]
b. 21 Apr 1848 d. 22 Sep 1911
+
Franklin F King
b. 1845 d. 1898
11
Cynthia Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.2.10]
b. 10 Nov 1850 d. 17 Apr 1851
10
Almira Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.3]
b. 13 Jun 1810 d. 4 Feb 1889
George Tiffany
b. 4 May 1808 d. 21 Jun 1885
11
Cynthia Jane Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.3.1]
b. 2 Feb 1830 d. 6 Oct 1845
11
Zenos Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.3.2]
b. 21 Jul 1831 d. Dec 1843
11
Ira Patchen Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.3.3]
b. 14 Feb 1835 d. 21 Mar 1905
Mary Ann Davis
b. 4 Oct 1843 d. 21 Jul 1885
12
Ira Davies Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.3.3.1]
b. 24 Jul 1863 d. 27 Oct 1902
12
Zenos William Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.3.3.2]
b. 21 Aug 1865 d. 14 Feb 1938
12
Sylvia Ann Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.3.3.3]
b. 14 Nov 1867 d. 23 Dec 1936
12
Cynthia Jane Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.3.3.4]
b. 27 Feb 1870 d. Bef 1877
12
Mary Elizabeth Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.3.3.5]
b. 17 May 1871 d. 5 Nov 1887
12
Almira Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.3.3.6]
b. 29 Dec 1873 d. 21 Sep 1887
12
Franklin Brayn Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.3.3.7]
b. 29 Feb 1876 d. 4 Oct 1877
12
Eliza Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.3.3.8]
b. 30 Jan 1878 d. 2 Jun 1957
12
George Hyrum Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.3.3.9]
b. 17 Apr 1880 d. 18 Mar 1939
12
Albert Henry Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.3.3.10]
b. 5 Nov 1882 d. 2 Dec 1956
12
Ray Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.3.3.11]
b. 21 Jul 1884 d. 16 Oct 1885
+
Sarah Ann Jolley
b. 18 Dec 1837 d. 9 Jan 1919
11
Loyal Peck Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.3.4]
b. 27 Jul 1837 d. 15 Feb 1903
+
Martha Holden
b. 28 Jan 1825 d. 3 May 1886
11
Mary Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.3.5]
b. 18 Dec 1844 d. 14 Dec 1845
11
Almira Rebecca Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.3.6]
b. 18 Aug 1847 d. 23 Nov 1914
Giles Bliss Holden
b. 8 May 1842 d. 20 May 1897
12
Almira Rebecca Holden
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.3.6.1]
b. 8 Aug 1865 d. 25 Aug 1865
12
Ruia Angeline Holden
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.3.6.2]
b. 21 Oct 1866 d. 4 Mar 1948
12
Giles Robert Holden
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.3.6.3]
b. 8 Dec 1868 d. Mar 1889
12
Cynthia Holden
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.3.6.4]
b. 10 Mar 1870 d. 10 Mar 1870
12
George Tiffany Holden
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.3.6.5]
b. 9 May 1872 d. 13 Apr 1934
12
Nellie May Holden
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.3.6.6]
b. 30 Dec 1875 d. 6 Nov 1935
12
Burrell Henry Holden
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.3.6.7]
b. 29 Jun 1877 d. 11 Mar 1881
12
Leroy Edwin Holden
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.3.6.8]
b. 21 Sep 1879 d. 12 Feb 1881
12
Ivy LeNore Holden
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.3.6.9]
b. 24 May 1882 d. 18 Aug 1958
12
Merle Dee Holden
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.3.6.10]
b. 10 Jul 1885 d. 12 Sep 1938
12
Verna Holden
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.3.6.11]
b. 18 Dec 1887 d. 18 Dec 1887
12
Vera Holden
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.3.6.12]
b. 18 Dec 1887 d. 12 Feb 1967 [
=>
]
11
George Mason Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.3.7]
b. 31 Jan 1850 d. 14 Mar 1909
Sarah Jane York
b. 18 Feb 1857 d. 27 Dec 1940
12
Mary Ellen Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.3.7.1]
b. 22 Aug 1874 d. 18 Jun 1958
12
Sarah Jane Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.3.7.2]
b. 16 Apr 1876 d. 23 Apr 1883
12
George Mason Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.3.7.3]
b. 17 Nov 1877 d. 21 Apr 1883
12
Asa York Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.3.7.4]
b. 24 Feb 1881 d. 3 Feb 1947
12
Lea Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.3.7.5]
b. 7 May 1883 d. 7 Jan 1961
12
Ira George Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.3.7.6]
b. 7 May 1883 d. 7 Jan 1961
12
Nelson Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.3.7.7]
b. 4 Aug 1885 d. 27 Mar 1943
12
Almira Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.3.7.8]
b. 16 Sep 1888 d. 26 Jul 1966
12
Ruia Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.3.7.9]
b. 27 Nov 1890 d. 15 May 1965
12
Lenore Henrietta Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.3.7.10]
b. 9 Aug 1893 d. 11 Sep 1967
11
Nelson Whipple Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.3.8]
b. 6 Aug 1852 d. 20 Jan 1927
Nancy Medora Beesley
b. 8 Sep 1862 d. 15 May 1924
12
Nelson Whipple Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.3.8.1]
b. 11 Sep 1880 d. 20 Nov 1904
12
Florence Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.3.8.2]
b. 27 Apr 1882 d. 22 May 1964
12
Alathea Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.3.8.3]
b. 28 Aug 1884 d. 3 Jan 1897
12
Ida May Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.3.8.4]
b. 15 Nov 1888 d. 9 May 1968
12
George Milton Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.3.8.5]
b. 8 May 1892 d. 25 May 1963
12
Martha Elva Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.3.8.6]
b. 1 Aug 1898 d. 25 Nov 1989
12
Viola Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.3.8.7]
b. 5 Jul 1903 d. 19 Jun 1969
10
Phoebe Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.4]
b. 13 Aug 1813 d. 18 Nov 1846
Benjamin Bengraw Shaw
b. 1808
11
Clymenia Azuba Shaw
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.4.1]
b. 2 Feb 1834 d. 10 Aug 1920
David Evans
b. 27 Oct 1804 d. 23 Jun 1883
12
Phebe Jane Evans
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.4.1.1]
b. 1 Dec 1855 d. 18 Dec 1855
12
James Evans
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.4.1.2]
b. 16 Aug 1857 d. 15 Apr 1940 [
=>
]
12
Edwin Thomas Evans
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.4.1.3]
b. 2 Feb 1860 d. 4 Mar 1946 [
=>
]
Benjamin Gibson
b. 9 May 1805 d. 26 Nov 1897
11
Hannah Gibson
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.4.2]
b. 24 Apr 1836 d. 31 Oct 1846
11
Isabella Amy Gibson
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.4.3]
b. 20 Mar 1838 d. 11 Feb 1898
William Coleman
b. 9 Dec 1836 d. 12 Feb 1910
12
William Coleman, Jr
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.4.3.1]
b. 3 Oct 1858 d. 19 Aug 1936 [
=>
]
12
Phebe Jane Coleman
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.4.3.2]
b. 20 May 1860 d. 11 Jun 1936 [
=>
]
12
Benjamin Leo Coleman
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.4.3.3]
b. 2 Sep 1862 d. 23 Jan 1937 [
=>
]
12
Amy Jane Coleman
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.4.3.4]
b. 13 May 1865 d. 19 Oct 1865
12
Mary Elizabeth Coleman
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.4.3.5]
b. 12 Apr 1866 d. 12 Dec 1869
12
John Coleman
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.4.3.6]
b. 6 Nov 1866 d. 24 Jul 1937 [
=>
]
12
Franklin Coleman
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.4.3.7]
b. 18 Mar 1868 d. 1 Jul 1917 [
=>
]
12
Hyrum Coleman
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.4.3.8]
b. 19 Aug 1868 d. 8 Oct 1947 [
=>
]
12
Prime Henry Coleman
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.4.3.9]
b. 24 Apr 1871 d. 30 Mar 1948
12
Sarah Francetta Coleman
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.4.3.10]
b. 20 Jun 1875 d. 9 May 1931 [
=>
]
12
Esther Coleman
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.4.3.11]
b. 8 Dec 1880 d. 1 Mar 1908 [
=>
]
11
Mary Jane Gibson
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.4.4]
b. 5 Feb 1840 d. 12 Jun 1912
Orson Kelsey
b. 1 Oct 1840 d. 7 May 1922
12
Mary Ellen Kelsey
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.4.4.1]
b. 22 Jan 1860 d. 28 Oct 1889 [
=>
]
12
Orson Kelsey, Jr
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.4.4.2]
b. 27 Aug 1861 d. 23 Mar 1904 [
=>
]
12
Benjamin Franklin Kelsey
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.4.4.3]
b. 6 Jun 1865 d. 28 Sep 1937 [
=>
]
12
Orin Kelsey
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.4.4.4]
b. 27 Sep 1866 d. 28 Sep 1866
12
George Albert Kelsey
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.4.4.5]
b. 6 Nov 1868 d. 10 Sep 1946
12
Theodore Kelsey
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.4.4.6]
b. 20 May 1871 d. 2 May 1963 [
=>
]
12
Abigail Kelsey
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.4.4.7]
b. 17 Feb 1873 d. 10 Dec 1956 [
=>
]
12
Easton Lemoine Kelsey
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.4.4.8]
b. 18 Oct 1875 d. 23 Jul 1963 [
=>
]
12
Amos C Kelsey
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.4.4.9]
b. 26 Jul 1876 d. 5 Sep 1956 [
=>
]
12
Rupert Lee Kelsey
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.4.4.10]
b. 8 Dec 1878 d. 12 Aug 1961 [
=>
]
12
Elmira Kelsey
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.4.4.11]
b. 10 Nov 1880 d. 19 Feb 1958 [
=>
]
12
Phoebe Jane Kelsey
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.4.4.12]
b. 23 Aug 1882 d. 16 Jul 1964 [
=>
]
11
Susan Jane Gibson
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.4.5]
b. 11 Oct 1842 d. 25 May 1929
John Franklin Sanders
b. 5 Mar 1830 d. 18 Mar 1896
12
Phebe Jane Sanders
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.4.5.1]
b. 23 Jan 1866 d. 9 May 1950 [
=>
]
12
Amanda Ann Sanders
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.4.5.2]
b. 14 Nov 1867 d. Aug 1868
12
Amy Elmira Sanders
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.4.5.3]
b. 8 Aug 1869 d. 25 Sep 1925
12
William Franklin Sanders
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.4.5.4]
b. 6 Jan 1872 d. 15 Nov 1906
12
Ellen Clymena Sanders
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.4.5.5]
b. 14 Jan 1874 d. 8 Oct 1953 [
=>
]
12
Joseph Myron Sanders
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.4.5.6]
b. 12 Mar 1876 d. 8 Jun 1944 [
=>
]
11
Jemima Gibson
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.4.6]
b. 1847
10
Carum Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.5]
b. 12 Aug 1815 d. 1843
10
Gerua Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.6]
b. 12 Aug 1815 d. 18 Sep 1848
10
Nelson Wheeler Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7]
b. 11 Jul 1818 d. 5 Jul 1887
Susan Jane Bailey
b. 9 Mar 1828 d. 5 Jun 1856
11
Son Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.1]
b. 15 Oct 1844 d. 15 Oct 1844
11
Miranda Jane Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.2]
b. 14 Mar 1847 d. 29 Dec 1907
+
John Williams
b. 8 Oct 1840 d. 21 May 1899
David R Barton
b. 1835
12
David Albert Barton
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.2.1]
b. 22 Jan 1865 d. 3 Sep 1930
12
Elizabeth M Barton
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.2.2]
b. Apr 1868 d. 15 Oct 1917 [
=>
]
12
Mary Ellen Barton
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.2.3]
b. 26 Jul 1870 d. 2 Feb 1926 [
=>
]
Henry Codd
b. 21 Aug 1836 d. 20 Jan 1911
12
Eliza Isabella Code
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.2.4]
b. 12 Nov 1873 d. 13 Mar 1911
12
Charles Levi Code
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.2.5]
b. 3 Apr 1876 d. 4 May 1954
12
Ruth Lorena Code
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.2.6]
b. 21 Apr 1880 d. 16 Nov 1939
12
Theda Maria Code
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.2.7]
b. 2 Jul 1883 d. 11 Jun 1932
11
Mary Janet Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.3]
b. 14 Feb 1849 d. Nov 1922
Charles Maynard
b. Abt 1849
12
Charles Maynard
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.3.1]
b. 1880
+
Richard Marlin Wadams
b. 4 Aug 1852 d. 11 Apr 1914
11
George Nelson Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.4]
b. 20 Mar 1851 d. 8 Jun 1912
Annie Baird
b. 5 Nov 1860 d. 1926
12
William Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.4.1]
b. Abt 1883 d. Abt 1888
12
Frank Henry Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.4.2]
b. 6 Dec 1885 d. 5 Sep 1946 [
=>
]
12
Edson George Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.4.3]
b. 25 Apr 1891 d. 4 Mar 1939
12
Ida Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.4.4]
b. Abt 1899 d. 4 Jun 1899
12
Mary Jannett Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.4.5]
b. 16 Apr 1900 d. 3 Aug 1900
12
Edith May Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.4.6]
b. 21 Nov 1903 d. 9 Oct 1945 [
=>
]
11
Edson Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.5]
b. 10 Oct 1853 d. 26 Feb 1909
Mary Ann Beck
b. 13 Jun 1865 d. 16 Jan 1937
12
Mary Magdaline Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.5.1]
b. 8 Oct 1881 d. 24 Feb 1964 [
=>
]
12
Susan Jane Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.5.2]
b. 17 Oct 1883 d. 25 Apr 1965 [
=>
]
12
William Edson Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.5.3]
b. 19 Oct 1885 d. 10 Mar 1976 [
=>
]
12
Luella Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.5.4]
b. 10 Jan 1888 d. 20 Feb 1924 [
=>
]
12
Amy Louisa Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.5.5]
b. 21 Sep 1890 d. 27 Mar 1972 [
=>
]
12
Delilah Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.5.6]
b. 16 Oct 1893 d. 25 Oct 1976 [
=>
]
12
Stanley Dean Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.5.7]
b. 13 Nov 1896 d. 25 Nov 1896
12
Leon Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.5.8]
b. 14 Jul 1899 d. 17 Jul 1966 [
=>
]
12
Vern George Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.5.9]
b. 10 Jan 1902 d. 9 May 1991
12
Kenneth Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.5.10]
b. 13 Jun 1904 d. 4 Apr 1973
11
Harriet Emily Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.6]
b. 21 Nov 1855 d. 4 Oct 1856
11
Annie Bard Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.7]
b. 5 Jun 1856
Susan Ann Gay
b. 13 Jun 1841 d. 29 Sep 1911
11
Martha Ellen Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.8]
b. 19 Jan 1858 d. 20 Oct 1937
Jacob Kesler
b. 30 Sep 1860 d. 25 Dec 1937
12
Hazel Gay Kesler
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.8.1]
b. 2 Apr 1884 d. 20 Dec 1956 [
=>
]
12
Essie Parthenia Kesler
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.8.2]
b. 23 Oct 1885 d. 29 Jul 1935
12
Frederick Nelson Kesler
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.8.3]
b. 22 Oct 1888 d. 13 Nov 1898
12
Dela Von Kesler
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.8.4]
b. 22 Feb 1890 d. 17 Jul 1934
12
Audrey Kesler
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.8.5]
b. 8 Jun 1893 d. 20 Apr 1897
12
Jacob Waldemar Kesler
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.8.6]
b. 23 Jan 1896 d. 8 Feb 1896
12
Martha Ellen Kesler
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.8.7]
b. 10 Sep 1897
11
Nelson Gay Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.9]
b. 21 Sep 1859 d. 2 Apr 1944
Susannah Wanless
b. 25 Apr 1866 d. 5 Jun 1949
12
William Nelson Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.9.1]
b. 22 Dec 1884 d. 30 May 1972 [
=>
]
12
John Gay Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.9.2]
b. 12 May 1887 d. 25 Jan 1949
12
James Anor Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.9.3]
b. 24 Feb 1889 d. 23 Jun 1946 [
=>
]
12
Raymond Leigh Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.9.4]
b. 17 May 1892 d. 9 Sep 1940
12
Marvian Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.9.5]
b. 11 Sep 1896 d. 26 Aug 1898
12
Frederick Dale Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.9.6]
b. 18 Mar 1908 d. 2 Oct 1960
11
Sylvia Gay Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.10]
b. 18 May 1862 d. 20 Jan 1940
Frederick Bateman Margetts
b. 9 Oct 1861 d. 7 Feb 1950
12
Fred Lynn Margetts
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.10.1]
b. 25 Sep 1885 d. 7 Jan 1971
12
Dora Estella Margetts
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.10.2]
b. 5 Mar 1887 d. 24 Jan 1963 [
=>
]
12
Paul Gay Margetts
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.10.3]
b. 12 Dec 1889 d. 6 Apr 1982 [
=>
]
12
Lucille Margetts
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.10.4]
b. 4 Mar 1893 d. 29 Oct 1959
12
Amy Jane Margetts
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.10.5]
b. 4 Oct 1895 d. 19 Feb 1952
12
Susan Ann Margetts
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.10.6]
b. 30 Mar 1898 d. 10 Oct 1995 [
=>
]
12
Anor Whipple Margetts
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.10.7]
b. 28 Feb 1900 d. 15 Apr 1969 [
=>
]
12
Nelson Whipple Margetts
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.10.8]
b. 2 Sep 1903 d. 20 Sep 1962 [
=>
]
11
Susan Ann Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.11]
b. 3 Nov 1864 d. 19 Dec 1935
Archer Walters Clayton
b. 10 Apr 1858 d. 27 Oct 1947
12
Archer Lynne Clayton
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.11.1]
b. 7 Jul 1883 d. 14 Oct 1952 [
=>
]
12
Don Carlos Clayton
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.11.2]
b. 15 Jan 1885 d. 14 Oct 1964 [
=>
]
12
Phyllis Clayton
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.11.3]
b. 29 Jun 1887 d. 13 Aug 1962 [
=>
]
12
Daughter Clayton
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.11.4]
b. 1889
12
Susan Ann Clayton
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.11.5]
b. 24 Dec 1891 d. 8 Jul 1977 [
=>
]
12
Alonzo Hyde Clayton
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.11.6]
b. 25 Apr 1893 d. 12 Apr 1984 [
=>
]
12
Ruth Clayton
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.11.7]
b. 16 Aug 1895 d. 12 May 1896
12
William Arthur Clayton
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.11.8]
b. 30 Aug 1897 d. 28 Jan 1980 [
=>
]
11
Alexander Samuel Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.12]
b. 2 Mar 1867 d. 8 Jan 1899
Sarah "Daisy" Van Natta
b. 8 May 1870 d. 18 Apr 1962
12
Mary Irene Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.12.1]
b. 16 Oct 1891 d. 5 Mar 1989 [
=>
]
12
Ida Jane Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.12.2]
b. 28 Jun 1894 d. 20 Feb 1968
11
Robert John Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.13]
b. 13 Nov 1869 d. 6 Nov 1954
Susie Winn
b. 10 Feb 1874 d. 8 Sep 1963
12
Ora Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.13.1]
b. 6 May 1897 d. 28 Apr 1956
12
Winnie Leath Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.13.2]
b. 21 Sep 1899 d. 23 Jun 1997 [
=>
]
12
Essie June Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.13.3]
b. 27 Jun 1902 d. 3 Jan 1984 [
=>
]
12
Byron John Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.13.4]
b. 15 Mar 1905 d. 19 Aug 1994 [
=>
]
12
Mildred Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.13.5]
b. 16 Nov 1907 d. 7 May 1987
12
Miriam Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.13.6]
b. 16 Nov 1907 d. 29 Jan 1981 [
=>
]
11
Amey Jane Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.14]
b. 15 Dec 1871 d. 6 Sep 1962
John Henry Evans
b. 29 Apr 1872 d. 24 Mar 1947
12
Emerson Whipple Evans
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.14.1]
b. 7 Apr 1901 d. 26 Mar 1973 [
=>
]
12
Alexander Whipple Evans
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.14.2]
b. 4 Aug 1902 d. 20 Apr 1954 [
=>
]
12
John Henry Evans, Jr
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.14.3]
b. 27 Jan 1903 d. 23 Jun 1988 [
=>
]
12
Gwendolyn Whipple Evans
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.14.4]
b. 2 Feb 1904 d. 21 Sep 1986 [
=>
]
12
Amy Evans
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.14.5]
b. 14 Feb 1909 d. 26 Dec 2001
12
Daughter Evans
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.14.6]
b. 20 Sep 1914 d. 20 Sep 1914
11
Ida Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.15]
b. 15 Dec 1873 d. 21 May 1956
Ezra Oakley Taylor
b. 20 May 1863 d. 19 Jul 1952
12
Mary Whipple Taylor
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.15.1]
b. 11 Feb 1897 d. 16 Apr 1953
12
Julia Whipple Taylor
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.15.2]
b. 6 Aug 1900 d. 27 Apr 1989 [
=>
]
12
Ezra Whipple Taylor
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.15.3]
b. 25 May 1904 d. 21 Jul 2001 [
=>
]
12
Ida Gay Taylor
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.15.4]
b. 19 Oct 1908 d. 23 Dec 2001
12
Irvin Whipple Taylor
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.15.5]
b. 16 Jul 1911 d. 4 Jul 1991 [
=>
]
12
Patricia Taylor
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.15.6]
b. 17 Mar 1919 d. 27 Sep 1997
11
Anor Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.16]
b. 25 Mar 1879 d. 23 Oct 1967
Aurilla May Watkins
b. 4 May 1884 d. 18 Apr 1976
12
Aurilla Gay Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.16.1]
b. 20 Aug 1918 d. 5 Mar 2011 [
=>
]
12
Roswell Watkins Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.16.2]
b. 4 Dec 1922 d. 1 Feb 2008
12
Helen Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.16.3]
b. 5 Feb 1926 d. 6 May 2009
Rachel Keeling
b. 10 Mar 1818 d. 16 Jun 1910
11
Daniel Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.17]
b. 12 Apr 1854 d. 12 Feb 1926
Ellen Hirst
b. 3 Feb 1862 d. 21 Dec 1935
12
Daniel LeRoy Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.17.1]
b. 28 Jul 1879 d. 7 Aug 1935 [
=>
]
12
George Wheeler Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.17.2]
b. 4 Aug 1881 d. 30 Sep 1965 [
=>
]
12
John Ernest Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.17.3]
b. 19 Feb 1883 d. 25 Jan 1946
12
Ella Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.17.4]
b. 27 Jan 1884 d. 29 Sep 1935 [
=>
]
12
Leonard Hirst Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.17.5]
b. 7 Jan 1887 d. 11 Nov 1970 [
=>
]
12
Orley Keeling Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.17.6]
b. 6 Apr 1895 d. 24 Sep 1962 [
=>
]
12
Eugene Brook "Dean" Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.17.7]
b. 29 Dec 1899 d. 31 May 1968 [
=>
]
11
Cynthia Delight Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.18]
b. 7 Jun 1857 d. 4 Sep 1858
11
Nelson Wheeler Whipple, Jr
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.19]
b. 15 Apr 1859 d. 30 Jun 1938
Mary Roberts
b. 15 Jul 1857 d. 23 Sep 1935
12
John Wheeler Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.19.1]
b. 19 Oct 1881 d. 3 Aug 1954 [
=>
]
12
Mable Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.19.2]
b. 4 Jul 1883 d. 8 Oct 1951 [
=>
]
12
Rachel Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.19.3]
b. 20 Dec 1885 d. 1 Jul 1886
12
Nelson Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.19.4]
b. 13 Mar 1887 d. 13 Mar 1887
12
Adelaide Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.19.5]
b. 5 May 1888 d. 21 Feb 1898
12
Lawrence Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.19.6]
b. 24 Sep 1891 d. 2 Apr 1934
12
Lillie May Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.19.7]
b. 6 May 1894 d. 20 Dec 1983 [
=>
]
12
Leslie Whipple
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.7.19.8]
b. 1 Oct 1898 d. Oct 1957 [
=>
]
Zenos Aldrich
b. Abt 1773 d. 8 Nov 1856
10
Sylvanus Aldrich
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.8]
b. 1799 d. 8 Nov 1856
10
Azuba Aldrich
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.9]
b. Abt 1801
Armstrong Baskins
b. 3 Apr 1786 d. 27 May 1842
11
Sarah Ann Baskins
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.9.1]
b. Abt 1824
11
Harriet N Baskins
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.9.2]
b. Abt 1830
11
Mary Jane Baskins
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.9.3]
b. 1832 d. 22 Dec 1850
11
Erastus Baskins
[1.2.3.6.3.1.7.4.9.9.4]
b. 1834 d. 3 Nov 1862
9
Azuba Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.10]
b. 22 Aug 1779 d. 13 Nov 1865
Jared Patchen
b. 5 Sep 1773 d. 1 May 1857
10
Martin Ray Patchen
[1.2.3.6.3.1.7.4.10.1]
b. 10 Feb 1799 d. 7 Feb 1842
10
Abigail Patchen
[1.2.3.6.3.1.7.4.10.2]
b. 23 Jan 1801 d. 7 Sep 1823
10
Emily Patchen
[1.2.3.6.3.1.7.4.10.3]
b. 1802 d. 16 Jul 1826
10
John Patchen
[1.2.3.6.3.1.7.4.10.4]
b. 14 Jan 1803 d. 23 Oct 1874
10
Ira Patchen
[1.2.3.6.3.1.7.4.10.5]
b. 10 Jun 1805
10
Polly Patchen
[1.2.3.6.3.1.7.4.10.6]
b. 20 Jan 1808 d. 21 Aug 1891
10
Mary Patchen
[1.2.3.6.3.1.7.4.10.7]
b. 20 Jan 1808 d. 23 Feb 1888
10
Jared Patchen
[1.2.3.6.3.1.7.4.10.8]
b. 6 Sep 1812
10
Sylvanus Aldridge Patchen
[1.2.3.6.3.1.7.4.10.9]
b. 27 Nov 1814 d. 10 Feb 1892
10
Azuba Ann Patchen
[1.2.3.6.3.1.7.4.10.10]
b. 4 Jun 1817 d. 29 Sep 1886
10
Hannah Lavinia Patchen
[1.2.3.6.3.1.7.4.10.11]
b. 24 Apr 1820
10
Samuel Lorenzo Patchen
[1.2.3.6.3.1.7.4.10.12]
b. 1 Aug 1823 d. 14 Jun 1867
10
Amy Patchen
[1.2.3.6.3.1.7.4.10.13]
b. Abt 5 Jul 1825
9
Phoebe Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.11]
b. 22 Aug 1781 d. 31 Dec 1855
Nathan S Stewart
b. 7 Mar 1771 d. 7 Aug 1866
10
Horace S Stewart
[1.2.3.6.3.1.7.4.11.1]
b. 15 Jun 1804 d. 7 Aug 1866
10
Erastus A Stewart
[1.2.3.6.3.1.7.4.11.2]
b. 10 Mar 1805 d. 10 Nov 1851
10
Elijah Burr Stewart
[1.2.3.6.3.1.7.4.11.3]
b. Abt 1809 d. 9 Nov 1880
10
Azuba Ann Stewart
[1.2.3.6.3.1.7.4.11.4]
b. 1810
10
Samuel Curtis Stewart
[1.2.3.6.3.1.7.4.11.5]
b. 1811 d. 25 Nov 1870
10
William Stewart
[1.2.3.6.3.1.7.4.11.6]
b. 1812
10
Azubam Stewart
[1.2.3.6.3.1.7.4.11.7]
b. 1812
10
Thomas Ryler Stewart
[1.2.3.6.3.1.7.4.11.8]
b. 1815
9
Amy Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.4.12]
b. 8 Dec 1783 d. 17 Dec 1857
Isaac Darrow
b. Abt 1779
10
John Tiffany Darrow
[1.2.3.6.3.1.7.4.12.1]
b. 17 Nov 1800 d. 13 Nov 1897
10
Affa Ward Darrow
[1.2.3.6.3.1.7.4.12.2]
b. 26 Dec 1803 d. 15 Apr 1875
10
Hannah Mead Darrow
[1.2.3.6.3.1.7.4.12.3]
b. 24 Apr 1806
10
Mary Cromwell Darrow
[1.2.3.6.3.1.7.4.12.4]
b. 9 May 1808 d. 18 Nov 1877
10
Ann Hubbard Darrow
[1.2.3.6.3.1.7.4.12.5]
b. 27 Mar 1811 d. 24 Jul 1890
10
Susan Pardee Darrow
[1.2.3.6.3.1.7.4.12.6]
b. 1813 d. 24 Jun 1890
8
Humphery Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.5]
b. 2 Mar 1742 d. 1831
Phebe Brown
b. Abt 1751 d. 1831
9
Lydia "Lidda" Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.5.1]
b. 13 May 1772 d. 1 Jul 1856
9
Susanna Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.5.2]
b. 28 Feb 1774
9
John C Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.5.3]
b. 17 Dec 1776 d. 9 Jul 1855
9
William Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.5.4]
b. Abt 1781 d. 12 Oct 1866
9
Phebe Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.5.5]
b. 1783
9
Humphrey Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.5.6]
b. 13 Sep 1788 d. 24 Jun 1870
9
Nelson Tiffany
[1.2.3.6.3.1.7.5.7]
b. 13 Sep 1808 d. 7 Sep 1869
7
Mary Comstock
[1.2.3.6.3.1.8]
b. Abt 1710
Nathan Beckwith
b. 22 Feb 1717 d. 24 Dec 1747
8
Mary Beckwith
[1.2.3.6.3.1.8.1]
b. Abt 1740 d. 10 Sep 1834
8
Ransom Beckwith
[1.2.3.6.3.1.8.2]
b. 12 Aug 1747
7
Samuel Comstock
[1.2.3.6.3.1.9]
b. Abt 1712 d. 1787
6
Moses Noyes
[1.2.3.6.3.2]
b. 1 Aug 1678 d. 10 Oct 1743
Mary Ely
b. 29 Nov 1689 d. 3 Feb 1764
7
Ruth Noyes
[1.2.3.6.3.2.1]
b. 1722 d. 14 May 1725
7
Moses Noyes
[1.2.3.6.3.2.2]
b. 1 Sep 1714 d. 23 Jul 1753
7
Ruth Noyes
[1.2.3.6.3.2.3]
b. 6 Jan 1716 d. 5 Feb 1719
7
Elizabeth Noyes
[1.2.3.6.3.2.4]
b. 1730 d. 8 May 1819
Jabez Sill
b. 4 Aug 1722 d. 14 Mar 1795
8
Elizabeth Noyes Sill
[1.2.3.6.3.2.4.1]
b. 22 Oct 1750 d. 27 Apr 1812
8
Mary Sill
[1.2.3.6.3.2.4.2]
b. 11 Jul 1752 d. 22 Apr 1842
8
Naomi Sill
[1.2.3.6.3.2.4.3]
b. 28 Nov 1754 d. 1838
8
Esther Sill
[1.2.3.6.3.2.4.4]
b. 1755 d. 7 Aug 1817
8
Shadrach Sill
[1.2.3.6.3.2.4.5]
b. 12 Aug 1758 d. 3 Nov 1813
8
Moses Sill
[1.2.3.6.3.2.4.6]
b. Abt 1760 d. Aug 1850
8
Dr Elisha Noyes Sill
[1.2.3.6.3.2.4.7]
b. 1761 d. 24 May 1845
8
Jabez Sill, Jr
[1.2.3.6.3.2.4.8]
b. 6 Mar 1763 d. 29 Jul 1838
8
Amasa Sill
[1.2.3.6.3.2.4.9]
b. 8 Jan 1767 d. 1772
8
Sarah Sill
[1.2.3.6.3.2.4.10]
b. 11 Oct 1770 d. 1779
7
William Noyes
[1.2.3.6.3.2.5]
b. 1735 d. 11 Feb 1807
Eunice Marvin
b. 2 Dec 1735 d. 5 Apr 1816
8
John Noyes
[1.2.3.6.3.2.5.1]
b. 18 Dec 1756 d. 1808
8
Captain Joseph Noyes
[1.2.3.6.3.2.5.2]
b. 1758 d. 1820
8
William Noyes
[1.2.3.6.3.2.5.3]
b. 30 Oct 1760 d. 23 Dec 1834
8
Matthew Noyes
[1.2.3.6.3.2.5.4]
b. 26 Feb 1764 d. 25 Sep 1839
6
Ruth Noyes
[1.2.3.6.3.3]
b. 6 Jan 1680 d. 5 May 1774
James Wadsworth
b. 1677 d. 1756
7
James Wadsworth
[1.2.3.6.3.3.1]
b. Abt 1700 d. 1777
Abigail Penfield
b. 22 Dec 1704 d. 1748
8
James Wadsworth
[1.2.3.6.3.3.1.1]
b. 8 Jul 1730 d. 22 Sep 1817
8
John Noyes Wadsworth
[1.2.3.6.3.3.1.2]
b. 1732 d. 1786
8
Ruth Wadsworth
[1.2.3.6.3.3.1.3]
b. 1743 d. 20 Jun 1813
Caleb Atwater
b. 7 Sep 1741 d. 19 Dec 1831
9
Anne Atwater
[1.2.3.6.3.3.1.3.1]
b. 17 Nov 1765
9
Joshua Atwater
[1.2.3.6.3.3.1.3.2]
b. Abt 1766
9
James Wadsworth Atwater
[1.2.3.6.3.3.1.3.3]
b. 30 Jun 1777 d. 30 Oct 1777
9
Abigail Atwater
[1.2.3.6.3.3.1.3.4]
b. 3 Dec 1778 d. 3 Sep 1834
9
Catharine Atwater
[1.2.3.6.3.3.1.3.5]
b. Abt 1780
9
Catherine "Kate" Atwater
[1.2.3.6.3.3.1.3.6]
b. 25 May 1781
9
Ruth Atwater
[1.2.3.6.3.3.1.3.7]
b. 11 Apr 1788 d. 2 Nov 1877
6
Sarah Noyes
[1.2.3.6.3.4]
b. 1682 d. 16 Aug 1756
Captain Timothy Mather
b. 20 Mar 1681 d. 25 Jul 1755
7
Timothy Mather
[1.2.3.6.3.4.1]
b. 9 Oct 1711
7
Joseph Mather
[1.2.3.6.3.4.2]
b. 23 Feb 1713 d. 5 Feb 1778
7
Ruth Mather
[1.2.3.6.3.4.3]
b. 3 Dec 1715 d. 4 Dec 1790
7
Catharine Mather
[1.2.3.6.3.4.4]
b. 1717 d. 4 Dec 1799
7
Moses Mather
[1.2.3.6.3.4.5]
b. 1718 d. 21 Sep 1806
6
John Noyes
[1.2.3.6.3.5]
b. 21 Jan 1688 d. 14 Feb 1755
Jane Dole
b. 23 Jan 1692 d. 14 Feb 1755
7
Josiah Noyes
[1.2.3.6.3.5.1]
b. 8 Sep 1712 d. 18 Feb 1796
7
Dorothy Noyes
[1.2.3.6.3.5.2]
b. 9 Apr 1715 d. 19 Mar 1798
7
Hannah Noyes
[1.2.3.6.3.5.3]
b. 6 Jul 1720 d. Bef Dec 1761
7
Jane Noyes
[1.2.3.6.3.5.4]
b. 8 Jan 1722
7
Oliver Noyes
[1.2.3.6.3.5.5]
b. 19 Mar 1724 d. 30 Apr 1725
7
Amos Noyes
[1.2.3.6.3.5.6]
b. 29 Jul 1728 d. 1752
7
Lieutenant colonel Peter Noyes
[1.2.3.6.3.5.7]
b. 3 Dec 1731 d. Aug 1796
5
John Noyes
[1.2.3.6.4]
b. 4 Jun 1649 d. 9 Nov 1678
Sarah Oliver
b. 7 Nov 1643 d. 19 Mar 1707
6
Sarah Noyes
[1.2.3.6.4.1]
b. 20 Aug 1672
6
John Noyes
[1.2.3.6.4.2]
b. 4 Nov 1674 d. 15 Mar 1749
Susanna Edwards
b. 29 Oct 1676
7
John Noyes
[1.2.3.6.4.2.1]
b. 17 Dec 1699 d. 1699
7
Sarah Noyes
[1.2.3.6.4.2.2]
b. 31 Mar 1701 d. 24 Aug 1702
7
Mary Noyes
[1.2.3.6.4.2.3]
b. 30 Oct 1703
7
Susanna Noyes
[1.2.3.6.4.2.4]
b. 15 Jun 1705
7
John Noyes
[1.2.3.6.4.2.5]
b. 26 Jun 1706 d. 26 Jun 1706
7
Sarah Noyes
[1.2.3.6.4.2.6]
b. 18 Sep 1712
7
Abigail Noyes
[1.2.3.6.4.2.7]
b. 21 May 1716 d. 12 Jun 1737
7
John Noyes
[1.2.3.6.4.2.8]
b. 8 Aug 1718
6
Dr Oliver Noyes
[1.2.3.6.4.3]
b. 1675 d. 16 Mar 1720
5
Thomas Noyes
[1.2.3.6.5]
b. 10 Aug 1648 d. 24 Apr 1730
Elizabeth Greenleaf
b. 5 Apr 1660 d. 30 Apr 1702
6
Moses Noyes
[1.2.3.6.5.1]
b. 29 Jan 1692 d. 1775
6
Mary Noyes
[1.2.3.6.5.2]
b. 8 Sep 1686 d. 1758
6
Parker Noyes
[1.2.3.6.5.3]
b. 29 Oct 1661 d. Bef 1710
6
Judith Noyes
[1.2.3.6.5.4]
b. Abt 1692 d. 30 Sep 1790
6
Thomas Noyes
[1.2.3.6.5.5]
b. 2 Oct 1679 d. 10 Jul 1753
6
Joseph Noyes
[1.2.3.6.5.6]
b. Abt 1686 d. 3 May 1750
6
Stephen Noyes
[1.2.3.6.5.7]
b. 6 Jul 1686
6
Elizabeth Noyes
[1.2.3.6.5.8]
b. 19 Feb 1684
6
Rebecca Noyes
[1.2.3.6.5.9]
b. 19 Apr 1700
5
Rebecca Noyes
[1.2.3.6.6]
b. 1 Apr 1651 d. 15 Oct 1719
John Knight
b. 16 Aug 1648 d. 7 Feb 1695
6
Bathsheba Knight
[1.2.3.6.6.1]
b. 1671
6
James Knight
[1.2.3.6.6.2]
b. 3 Sep 1672 d. Mar 1736
6
Rebecca Knight
[1.2.3.6.6.3]
b. 27 Apr 1674 d. Aft 1700
6
Mary Knight
[1.2.3.6.6.4]
b. Abt 1674 d. Abt 1725
Stephen Thurston
b. 5 Feb 1674
7
Moses Thurston
[1.2.3.6.6.4.1]
b. 19 Jul 1707 d. 12 Oct 1756
7
John Thurston
[1.2.3.6.6.4.2]
b. 29 Aug 1709 d. 28 Apr 1773
7
Rebecca Thurston
[1.2.3.6.6.4.3]
b. 1711
7
Robert Thurston
[1.2.3.6.6.4.4]
b. 25 Feb 1713 d. 16 Feb 1752
7
Daniel Thurston
[1.2.3.6.6.4.5]
b. 27 Aug 1714 d. 16 Feb 1737
7
Mary Thurston
[1.2.3.6.6.4.6]
b. 2 Jun 1716 d. 12 Oct 1775
7
Nathanial Thurston
[1.2.3.6.6.4.7]
b. 12 Jul 1718 d. 12 Oct 1775
7
Stephen Thurston
[1.2.3.6.6.4.8]
b. Abt 1720 d. 27 Nov 1732
7
Mehitable Thurston
[1.2.3.6.6.4.9]
b. 1721
6
Sarah Knight
[1.2.3.6.6.5]
b. 10 Dec 1675 d. 16 Aug 1690
6
John Knight
[1.2.3.6.6.6]
b. 3 Apr 1676 d. Aft 1725
6
Nathaniel Knight
[1.2.3.6.6.7]
b. 22 Dec 1688 d. 29 Oct 1754
6
Joseph Knight
[1.2.3.6.6.8]
b. 9 Oct 1683 d. 31 Jan 1746
6
Elizabeth Knight
[1.2.3.6.6.9]
b. 5 Jul 1696 d. 5 Jul 1774
5
William Noyes
[1.2.3.6.7]
b. 22 Sep 1653 d. 10 Mar 1744
Sarah Cogswell
b. 3 Feb 1668 d. Bef 1716
6
Moses Noyes
[1.2.3.6.7.1]
b. 27 Jan 1693 d. 16 Feb 1693
6
Mary Noyes
[1.2.3.6.7.2]
b. 24 May 1699 d. 16 Dec 1703
6
Sarah Noyes
[1.2.3.6.7.3]
b. 10 May 1691 d. 3 Dec 1703
6
John Noyes
[1.2.3.6.7.4]
b. 27 Jul 1686 d. 4 Jan 1772
6
Seusanah Noyes
[1.2.3.6.7.5]
b. Abt 1687 d. 6 Apr 1754
6
Parker Noyes
[1.2.3.6.7.6]
b. 17 Jan 1704 d. 22 Sep 1784
5
Sarah Noyes
[1.2.3.6.8]
b. 21 Mar 1655 d. 20 May 1697
John Hale
b. 24 Mar 1675 d. 4 Apr 1761
6
James Hale
[1.2.3.6.8.1]
b. 14 Oct 1685 d. 22 Nov 1742
Sarah Hathaway
b. Abt 1686
7
John Hale
[1.2.3.6.8.1.1]
b. 19 Apr 1715 d. 7 Jun 1738
7
James Hale, Jr
[1.2.3.6.8.1.2]
b. 9 Feb 1716 d. Bef 1774
6
John Hale
[1.2.3.6.8.2]
b. 24 Jun 1686 d. 29 Nov 1739
6
Samuel Hale
[1.2.3.6.8.3]
b. 13 Aug 1687 d. 29 May 1724
6
Joanna Hale
[1.2.3.6.8.4]
b. 15 Jun 1689 d. 1713
6
Robert Hale
[1.2.3.6.8.5]
b. 3 Nov 1688 d. 1719
6
John Hale
[1.2.3.6.8.6]
b. 24 Dec 1692
4
Mary Noyes
[1.2.3.7]
b. Abt 1610 d. 3 Aug 1696
4
John Noyes
[1.2.3.8]
b. 1612 d. Aft 24 Jul 1660
4
Ann Noyes
[1.2.3.9]
b. 1613 d. 16 Oct 1671
Thomas Kent
b. 13 Jun 1609 d. 1 May 1658
5
Samuel Kent
[1.2.3.9.1]
b. Abt 1634 d. 2 Feb 1691
5
Thomas Kent
[1.2.3.9.2]
b. Abt 1634 d. 14 Aug 1691
5
Josiah Kent
[1.2.3.9.3]
b. Abt 1636 d. 19 May 1725
4
Nicholas Noyes
[1.2.3.10]
b. 23 Nov 1614 d. 23 Nov 1701
Mary Cutting
b. Apr 1622 d. 28 Dec 1701
5
Margerie Moyes
[1.2.3.10.1]
b. 1 Oct 1639
John S Kyle
b. Abt 1635
6
James Kyle
[1.2.3.10.1.1]
b. Abt 1660 d. 1735
Isabel Dickson
b. 1660
7
Thomas Kyle
[1.2.3.10.1.1.1]
b. 1683
7
John Kyle
[1.2.3.10.1.1.2]
b. Abt 1684 d. 1759
7
Mary Kyle
[1.2.3.10.1.1.3]
b. 1685 d. 20 Jan 1757
7
James Kyle
[1.2.3.10.1.1.4]
b. Abt 1686 d. Aft 1760
7
Robert Kyle
[1.2.3.10.1.1.5]
b. Abt 1690 d. 1783
6
Mark Kyle
[1.2.3.10.1.2]
b. Abt 1665 d. Aft 1692
Margaret Sheivell
c. 17 Mar 1667
7
William Kyle
[1.2.3.10.1.2.1]
b. 18 May 1690
7
Thomas Kyle
[1.2.3.10.1.2.2]
b. 5 Apr 1691
7
John Kyle
[1.2.3.10.1.2.3]
b. 7 Jul 1692
7
Isabel Kyle
[1.2.3.10.1.2.4]
b. Abt 11 Dec 1692 d. Bef 20 Nov 1713
5
Hannah Noyes
[1.2.3.10.2]
b. 13 Oct 1643 d. 5 Jan 1705
5
John Noyes
[1.2.3.10.3]
b. 20 Jan 1645
Mary E Poore
b. 21 Mar 1651 d. 1716
6
Samuel Noyes
[1.2.3.10.3.1]
b. 5 Feb 1690 d. 6 Nov 1729
Hannah Poore
b. 19 Jul 1692 d. 6 Nov 1729
7
John Noyes
[1.2.3.10.3.1.1]
b. 7 Apr 1720 d. 30 May 1770
Abigail Poore
b. 6 Jun 1721 d. 19 Mar 1814
8
Benjamin Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1]
b. 29 Apr 1742 d. 16 Mar 1811
Hannah Thompson
b. 2 Dec 1744 d. 4 Nov 1828
9
Abigail Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.1]
b. 11 Nov 1766 d. 27 Jul 1857
James Buntin
b. 18 Dec 1765 d. 13 Jan 1840
10
James Buntin
[1.2.3.10.3.1.1.1.1.1]
b. 20 Jun 1788
10
Hannah Buntin
[1.2.3.10.3.1.1.1.1.2]
b. 1 Nov 1790
10
Jane Buntin
[1.2.3.10.3.1.1.1.1.3]
b. 3 Jun 1792
10
Benjamin Buntin
[1.2.3.10.3.1.1.1.1.4]
b. 2 Aug 1795
10
John Buntin
[1.2.3.10.3.1.1.1.1.5]
b. 29 Jun 1797
10
Abagail Buntin
[1.2.3.10.3.1.1.1.1.6]
b. 27 Dec 1799
10
Abigail Buntin
[1.2.3.10.3.1.1.1.1.7]
b. 1800 d. 7 Jul 1862
Benjamin Noyes
b. 17 Nov 1799 d. 17 Sep 1882
11
Betsey Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.1.7.1]
b. 27 Aug 1801
11
Mary Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.1.7.2]
b. 6 Jan 1803
11
Sarah Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.1.7.3]
b. 9 Jan 1804
11
Hiram Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.1.7.4]
b. 13 Mar 1806
11
Hannah Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.1.7.5]
b. 28 Nov 1807
11
John Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.1.7.6]
b. 3 Jun 1809
11
Eliza Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.1.7.7]
b. 24 Sep 1811
11
Moses Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.1.7.8]
b. 23 Mar 1813
11
Jane L Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.1.7.9]
b. 1 May 1816
11
Andrew Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.1.7.10]
b. 3 Mar 1823
Saluria Colby
b. 17 Dec 1827
12
Hiram Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.1.7.10.1]
b. 18 Oct 1851 d. 21 Feb 1893 [
=>
]
11
Benjamin Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.1.7.11]
b. Abt Aug 1827 d. 26 Feb 1865
Marian C White
b. 1835
12
Lucy Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.1.7.11.1]
b. 1858 d. 1858
12
Otis Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.1.7.11.2]
b. 1859
12
Laura Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.1.7.11.3]
b. 1861 d. 1861
12
Lucy Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.1.7.11.4]
b. 1863 d. 1 May 1864
11
Saluria L Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.1.7.12]
b. 17 Dec 1827
11
Sarah Moyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.1.7.13]
b. 1831 d. 1897
10
Sally Buntin
[1.2.3.10.3.1.1.1.1.8]
b. 24 Feb 1802
10
Andrew Buntin
[1.2.3.10.3.1.1.1.1.9]
b. 20 Feb 1806
10
Mary Jane Buntin
[1.2.3.10.3.1.1.1.1.10]
b. 1808
9
Clement Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.2]
b. 20 Dec 1768 d. 15 Jun 1836
9
Hannah Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.3]
b. 18 Jan 1771 d. 28 Mar 1858
9
Thomas Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.4]
b. 8 Mar 1773 d. 13 Aug 1833
Sarah "Sally" Hemphill
b. 25 Apr 1773 d. 19 Aug 1831
10
Mary Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.4.1]
b. 6 Jan 1793 d. 10 Sep 1832
10
Polly Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.4.2]
b. 8 Feb 1796 d. 26 Jan 1800
10
James Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.4.3]
b. 24 Sep 1797
10
Benjamin Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.4.4]
b. 17 Nov 1799 d. 17 Sep 1882
Abigail Buntin
b. 1800 d. 7 Jul 1862
11
Betsey Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.4.4.1]
b. 27 Aug 1801
11
Mary Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.4.4.2]
b. 6 Jan 1803
11
Sarah Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.4.4.3]
b. 9 Jan 1804
11
Hiram Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.4.4.4]
b. 13 Mar 1806
11
Hannah Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.4.4.5]
b. 28 Nov 1807
11
John Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.4.4.6]
b. 3 Jun 1809
11
Eliza Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.4.4.7]
b. 24 Sep 1811
11
Moses Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.4.4.8]
b. 23 Mar 1813
11
Jane L Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.4.4.9]
b. 1 May 1816
11
Andrew Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.4.4.10]
b. 3 Mar 1823
Saluria Colby
b. 17 Dec 1827
12
Hiram Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.4.4.10.1]
b. 18 Oct 1851 d. 21 Feb 1893 [
=>
]
11
Benjamin Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.4.4.11]
b. Abt Aug 1827 d. 26 Feb 1865
Marian C White
b. 1835
12
Lucy Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.4.4.11.1]
b. 1858 d. 1858
12
Otis Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.4.4.11.2]
b. 1859
12
Laura Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.4.4.11.3]
b. 1861 d. 1861
12
Lucy Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.4.4.11.4]
b. 1863 d. 1 May 1864
11
Saluria L Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.4.4.12]
b. 17 Dec 1827
11
Sarah Moyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.4.4.13]
b. 1831 d. 1897
10
Betsey H Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.4.5]
b. 27 Apr 1801
Levi Mudgett
b. 10 Apr 1801 d. 10 Apr 1831
11
William Thomas Mudgett
[1.2.3.10.3.1.1.1.4.5.1]
b. 17 Apr 1831
10
Sarah H Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.4.6]
b. 9 Jun 1804
+
Caburn Kendall
10
Hiram Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.4.7]
b. 13 Mar 1806 d. 10 Feb 1849
+
Lois Terry
b. 25 Jul 1811 d. 2 Jun 1839
10
Hannah Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.4.8]
b. 28 Nov 1807 d. 2 Oct 1840
10
John Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.4.9]
b. 3 Jun 1809
Fannie Whitney
b. 1810
11
Sarah Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.4.9.1]
b. 1843
11
George P Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.4.9.2]
b. 30 Jun 1845
11
Books H Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.4.9.3]
b. 26 Dec 1855
Clara G Pierce
b. 1855
12
William L Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.4.9.3.1]
b. 2 Oct 1884 [
=>
]
12
Elizabeth G Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.4.9.3.2]
b. 7 Jun 1886
12
Lora H Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.4.9.3.3]
b. 30 Mar 1888
12
Marion F H Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.4.9.3.4]
b. 6 Aug 1889
12
Maybell E Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.4.9.3.5]
b. 14 Dec 1892
10
Moses K Moses
[1.2.3.10.3.1.1.1.4.10]
b. 23 Mar 1813 d. 22 Dec 1893
Mercy W White
b. Abt 1816
11
George K Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.4.10.1]
b. 17 Oct 1839
+
Elizabeth B White
11
Elizabeth J Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.4.10.2]
b. 30 Aug 1841
+
Samuel Patch
11
Rosanna F Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.4.10.3]
b. 16 May 1846
+
Josiah H Chase
11
Juniata G Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.4.10.4]
b. 5 Dec 1848
11
Alfaretta L Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.4.10.5]
b. 5 Dec 1848
+
Oliver H Godfrey
10
Eliza Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.4.11]
b. 24 Sep 1814 d. 13 Sep 1841
10
Jane L Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.4.12]
b. 1 May 1818
+
Moors Patee
9
Judith Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.5]
b. 15 Oct 1777 d. 28 May 1868
Robert Thompson
b. 1774
10
Mary Thompson
[1.2.3.10.3.1.1.1.5.1]
b. 7 Dec 1799 d. 19 Feb 1879
Jeremiah Hall Wilkins
b. 25 Dec 1791 d. 1864
11
Sarah Wilkins
[1.2.3.10.3.1.1.1.5.1.1]
b. 28 Feb 1818 d. 11 Oct 1887
David Austen
b. 20 Mar 1808 d. 2 Feb 1884
12
George Augustus Austin
[1.2.3.10.3.1.1.1.5.1.1.1]
b. 5 Jun 1841 d. 1907
12
Mary Willis Austin
[1.2.3.10.3.1.1.1.5.1.1.2]
b. 18 Mar 1850 [
=>
]
11
Charles Wilkins
[1.2.3.10.3.1.1.1.5.1.2]
b. 21 Dec 1819 d. 2 Nov 1820
11
Alanson Wilkins
[1.2.3.10.3.1.1.1.5.1.3]
b. 31 Mar 1822 d. 16 Jun 1863
11
Sophia Wilkins
[1.2.3.10.3.1.1.1.5.1.4]
b. 5 Aug 1824 d. 24 Nov 1869
Samuel Agustus Chandler
b. 25 Feb 1805 d. 11 Feb 1855
12
Helen Maria Chandler
[1.2.3.10.3.1.1.1.5.1.4.1]
b. 9 Apr 1849
11
Francis Wilkins
[1.2.3.10.3.1.1.1.5.1.5]
b. 3 Apr 1826 d. 15 Mar 1901
+
Ann George
11
George Wilkins
[1.2.3.10.3.1.1.1.5.1.6]
b. 29 Dec 1827 d. 22 Jul 1829
11
Caroline Wilkins
[1.2.3.10.3.1.1.1.5.1.7]
b. 15 Sep 1831 d. 15 Sep 1857
+
Franklin Hale
b. Abt 1829 d. Bef 25 Sep 1857
11
Thompson Wilkins
[1.2.3.10.3.1.1.1.5.1.8]
b. 27 Dec 1832 d. 3 Oct 1833
11
Henry Wilkins
[1.2.3.10.3.1.1.1.5.1.9]
b. 7 Jul 1836
11
Charlotte Wilkins
[1.2.3.10.3.1.1.1.5.1.10]
b. 27 Jun 1838 d. 13 Jun 1840
11
Harriet Wilkins
[1.2.3.10.3.1.1.1.5.1.11]
b. 23 Mar 1840
11
Mary Esther Wilkins
[1.2.3.10.3.1.1.1.5.1.12]
b. 23 Mar 1840
+
John Sullivan
b. Abt 1838
11
Joseph Wilkins
[1.2.3.10.3.1.1.1.5.1.13]
b. 24 May 1844
+
Laura J Emery
b. 4 Jan 1850
11
Harriet Wilkins
[1.2.3.10.3.1.1.1.5.1.14]
b. Apr 1848
+
Frederick Eugene Potter
b. 3 Jul 1839 d. 18 Nov 1902
10
Polly Thompson
[1.2.3.10.3.1.1.1.5.2]
b. 7 Dec 1799 d. 19 May 1879
10
Robert Thompson
[1.2.3.10.3.1.1.1.5.3]
b. 24 Apr 1803
9
Mary Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.6]
b. 11 Jun 1779 d. 24 May 1858
+
Martin
9
Phoebe Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.7]
b. 10 Sep 1784 d. 11 Sep 1880
William Taggart
b. 19 Mar 1781 d. 30 Apr 1861
10
William Taggart
[1.2.3.10.3.1.1.1.7.1]
b. Abt 1803
10
Henry Taggart
[1.2.3.10.3.1.1.1.7.2]
b. Abt 1805
10
Eliza Taggart
[1.2.3.10.3.1.1.1.7.3]
b. 8 Mar 1807 d. 13 Apr 1862
James B Colby
b. 21 Nov 1808 d. 15 Nov 1876
11
Julia Ann Colby
[1.2.3.10.3.1.1.1.7.3.1]
b. 11 Nov 1835
Caleb Austin Colby
b. 17 May 1847
12
Eldora Adela Colby
[1.2.3.10.3.1.1.1.7.3.1.1]
b. 30 Oct 1854 [
=>
]
12
James E Colby
[1.2.3.10.3.1.1.1.7.3.1.2]
b. 8 Nov 1857 [
=>
]
12
Julia Colby
[1.2.3.10.3.1.1.1.7.3.1.3]
b. Abt 1859
+
Charles H Morrey
b. 1855
11
Aaron Colby
[1.2.3.10.3.1.1.1.7.3.2]
b. 26 Jun 1838 d. 7 Oct 1891
Sarah Frances White
b. 9 Dec 1839
12
Son Colby
[1.2.3.10.3.1.1.1.7.3.2.1]
b. 4 Apr 1858
12
Fred Aaron Colby
[1.2.3.10.3.1.1.1.7.3.2.2]
b. 4 Jun 1858 [
=>
]
12
Hattie F Colby
[1.2.3.10.3.1.1.1.7.3.2.3]
b. 20 Aug 1860
11
Jane Colby
[1.2.3.10.3.1.1.1.7.3.3]
b. 15 May 1841 d. 17 Jul 1844
11
Mary B Colby
[1.2.3.10.3.1.1.1.7.3.4]
b. 16 May 1844
10
Leonard Taggart
[1.2.3.10.3.1.1.1.7.4]
b. Abt 1809
Nancy J Green
b. 27 Sep 1820 d. 17 Sep 1893
11
James G Taggart
[1.2.3.10.3.1.1.1.7.4.1]
b. Abt 1842
11
James Leonard Taggert
[1.2.3.10.3.1.1.1.7.4.2]
b. 25 Dec 1846 d. 13 Jun 1932
Oello Abbey Hay
b. 9 Jul 1861 d. 2 Feb 1945
12
Leonard James Taggart
[1.2.3.10.3.1.1.1.7.4.2.1]
b. 2 Jul 1882 [
=>
]
12
Ethel Cleota Taggart
[1.2.3.10.3.1.1.1.7.4.2.2]
b. Jan 1884 d. 10 Dec 1961 [
=>
]
Clara May Hoover
b. 8 May 1877 d. 4 Aug 1924
12
Walter Taggart
[1.2.3.10.3.1.1.1.7.4.2.3]
b. 20 May 1897 d. 5 Nov 1946
12
Lillian Ogar Taggart
[1.2.3.10.3.1.1.1.7.4.2.4]
b. 8 Sep 1899 d. 21 Aug 1977 [
=>
]
12
James O L Taggart
[1.2.3.10.3.1.1.1.7.4.2.5]
b. Abt 1900
10
Jane Taggart
[1.2.3.10.3.1.1.1.7.5]
b. 1812 d. 2 Apr 1898
Samuel Rogers Green
b. 22 Mar 1806 d. 21 Nov 1877
11
Benjamin T Green
[1.2.3.10.3.1.1.1.7.5.1]
b. 6 Jan 1837 d. 20 Nov 1923
+
Anna J Woodbury
b. 19 Jun 1854 d. 9 Sep 1930
11
Charles Shattuck Green
[1.2.3.10.3.1.1.1.7.5.2]
b. 19 Oct 1840 d. 7 May 1911
11
Henry T Green
[1.2.3.10.3.1.1.1.7.5.3]
b. 23 Sep 1844 d. 12 Sep 1849
11
John B Green
[1.2.3.10.3.1.1.1.7.5.4]
b. 21 May 1845
10
Mary Taggart
[1.2.3.10.3.1.1.1.7.6]
b. Abt 1813
9
Benning Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.8]
b. 9 Dec 1780 d. 2 Nov 1814
Hannah Story
b. 6 Sep 1784 d. 24 Nov 1857
10
Benjamin Abbott Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.8.1]
b. 10 Jul 1809 d. 1892
Jane Roach
b. 1806
11
Benjamin F Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.8.1.1]
b. 15 Jun 1836 d. 22 Dec 1833
11
George W Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.8.1.2]
b. 19 Apr 1842 d. Abt 1907
Francena Messer
b. 24 Feb 1844 d. Abt 1864
12
Lizzie F Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.8.1.2.1]
b. 1862
12
Ada A Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.8.1.2.2]
b. 21 Jul 1864 d. 24 Jan 1938 [
=>
]
+
Mary Fowler
b. Abt 1814
10
Jeremiah Story Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.8.2]
b. 7 Jun 1811 d. 16 Jan 1894
Caroline Bates
b. 16 May 1812
11
Charles Henry Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.8.2.1]
b. 29 Aug 1834
+
Mary A Shallis
b. 1835
11
Annie Eliza Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.8.2.2]
b. 24 Sep 1839
10
Hannah Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.8.3]
b. 3 Aug 1813
John Parker
b. 1813 d. 4 Sep 1836
11
John Parker
[1.2.3.10.3.1.1.1.8.3.1]
b. 29 Aug 1833 d. 17 Aug 1836
11
Francis Parker
[1.2.3.10.3.1.1.1.8.3.2]
b. 20 Jun 1835
9
Jane Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.9]
b. 10 Aug 1782 d. 21 May 1840
9
Elizabeth Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.10]
b. 10 Aug 1782
+
Samuel Story
9
Sally Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.1.11]
b. 21 Jan 1786
Leonard Pratt
b. 7 Oct 1781
10
Eliza Pratt
[1.2.3.10.3.1.1.1.11.1]
b. 11 Feb 1809
10
Child Pratt
[1.2.3.10.3.1.1.1.11.2]
b. Abt 1811
10
Child Pratt
[1.2.3.10.3.1.1.1.11.3]
b. Abt 1813
8
John Noyes, Jr
[1.2.3.10.3.1.1.2]
b. 13 Mar 1744 d. 7 Oct 1825
Mary Fowler
b. 22 Mar 1744 d. 14 Jan 1826
9
Abigail Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.1]
b. 28 Jan 1764 d. 1 Feb 1842
+
James Moore
b. 1760 d. 27 Aug 1835
9
John P Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.2]
b. 27 Jun 1766
Martha Haseltine
b. Abt 1767
10
Betsey Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.2.1]
b. 1789
10
John Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.2.2]
b. 1791
10
Ruth Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.2.3]
b. 1793
+
Timothy Hammond
10
Daughter Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.2.4]
b. 1795
10
Mary Abigal Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.2.5]
b. 24 Sep 1799 d. 16 Nov 1872
Winthrop Folsom
b. 27 Jan 1794 d. 18 Sep 1856
11
Asahel Blake Folsom
[1.2.3.10.3.1.1.2.2.5.1]
b. Abt 1816 d. 16 Oct 1848
Mary Dickey Cogswell
b. 20 Nov 1821
12
Emily Abigail Fullsome
[1.2.3.10.3.1.1.2.2.5.1.1]
b. 4 Mar 1845 d. 2 Feb 1868
11
Gilman Folsom
[1.2.3.10.3.1.1.2.2.5.2]
b. 7 Apr 1818 d. 15 Jul 1872
Emily Arthur
b. 23 Oct 1826 d. 13 Jun 1901
12
James Folsom
[1.2.3.10.3.1.1.2.2.5.2.1]
b. 29 May 1845 d. 27 Jan 1929
12
Mary Agnes Folsom
[1.2.3.10.3.1.1.2.2.5.2.2]
b. 3 Dec 1847 d. 5 Aug 1930
12
Arthur Folsom
[1.2.3.10.3.1.1.2.2.5.2.3]
b. 12 May 1851 d. 16 Jan 1933
12
George Jones Folsom
[1.2.3.10.3.1.1.2.2.5.2.4]
b. 6 Nov 1856 d. 24 Dec 1933
11
Susan Pickering Folsom
[1.2.3.10.3.1.1.2.2.5.3]
b. Abt 1825 d. 22 Oct 1895
Alden Fletcher
b. 11 Jul 1825 d. 1 Oct 1897
12
Gilman F Fletcher
[1.2.3.10.3.1.1.2.2.5.3.1]
b. 6 Mar 1848 [
=>
]
12
Anna Fletcher
[1.2.3.10.3.1.1.2.2.5.3.2]
b. 1849 [
=>
]
12
Susan Elizabeth Fletcher
[1.2.3.10.3.1.1.2.2.5.3.3]
b. 1854 d. 18 Aug 1856
12
Jesse W Fletcher
[1.2.3.10.3.1.1.2.2.5.3.4]
b. Abt Jan 1857 d. 9 Feb 1857
12
Frank Fletcher
[1.2.3.10.3.1.1.2.2.5.3.5]
b. 6 Sep 1858 d. 27 Aug 1934
12
Mary Emily Fletcher
[1.2.3.10.3.1.1.2.2.5.3.6]
b. 4 May 1861 d. 27 Feb 1926
12
Lucy Helen Fletcher
[1.2.3.10.3.1.1.2.2.5.3.7]
b. 3 Nov 1863 d. 24 Mar 1930
11
Mary D Folsom
[1.2.3.10.3.1.1.2.2.5.4]
b. Abt 1832
10
Matilda Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.2.6]
b. 25 Sep 1802
+
Job Willis
9
Sarah Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.3]
b. 17 Dec 1768 d. 28 Dec 1854
Ballard Hazelton
b. 4 Sep 1769 d. 1836
10
Peter Hazelton
[1.2.3.10.3.1.1.2.3.1]
b. 7 Jan 1793 d. 22 Dec 1846
Sarah "Sally" Pearse
b. 1 Dec 1787 d. 14 Jan 1852
11
Nancy Jane Hazelton
[1.2.3.10.3.1.1.2.3.1.1]
b. 24 Sep 1812 d. 25 Dec 1891
Alexander Cummings
b. 1808
12
Lelia Luella Hazelton
[1.2.3.10.3.1.1.2.3.1.1.1]
b. 24 Feb 1850 d. 3 Sep 1929 [
=>
]
11
Pearse Richardson Hazelton
[1.2.3.10.3.1.1.2.3.1.2]
b. 27 Feb 1821 d. 8 Mar 1878
11
Aaron Carter Hazelton
[1.2.3.10.3.1.1.2.3.1.3]
b. 22 Apr 1822 d. 10 Mar 1906
11
Peter Clark Hazelton
[1.2.3.10.3.1.1.2.3.1.4]
b. 1825 d. Aug 1845
11
Mary Ann Hazelton
[1.2.3.10.3.1.1.2.3.1.5]
b. 1827 d. 1857
11
Brooks Bowman Hazelton
[1.2.3.10.3.1.1.2.3.1.6]
b. 10 May 1829 d. 10 Dec 1899
11
Jeanette Hazelton
[1.2.3.10.3.1.1.2.3.1.7]
b. 10 Mar 1834 d. 7 Oct 1881
10
John Hazelton
[1.2.3.10.3.1.1.2.3.2]
b. 12 Oct 1794
10
Nathaniel Hazelton
[1.2.3.10.3.1.1.2.3.3]
b. 2 Dec 1797
10
Joseph Hazelton
[1.2.3.10.3.1.1.2.3.4]
b. 29 Nov 1799
10
Eliza Hazelton
[1.2.3.10.3.1.1.2.3.5]
b. 5 Dec 1802
10
Mary Ann Hazelton
[1.2.3.10.3.1.1.2.3.6]
b. 21 May 1805 d. 7 Apr 1868
10
Emily Hazelton
[1.2.3.10.3.1.1.2.3.7]
b. 3 Aug 1807
10
Sally Stickney Hazelton
[1.2.3.10.3.1.1.2.3.8]
b. 16 Jul 1809
10
George Washington Hazelton
[1.2.3.10.3.1.1.2.3.9]
b. 18 Feb 1812 d. 27 Aug 1864
10
Nancy Jane Hazelton
[1.2.3.10.3.1.1.2.3.10]
b. 24 Sep 1812 d. 25 Dec 1891
Alexander Cummings
b. 1808
11
Lelia Luella Hazelton
[1.2.3.10.3.1.1.2.3.10.1]
b. 24 Feb 1850 d. 3 Sep 1929
Oscar Ansen Ware
b. 5 Oct 1844 d. Jul 1923
12
Walter Leon Ware
[1.2.3.10.3.1.1.2.3.10.1.1]
b. 24 Feb 1867 d. 19 Aug 1929 [
=>
]
12
Alma Bell Ware
[1.2.3.10.3.1.1.2.3.10.1.2]
b. 24 Jan 1869 d. 26 Jul 1948 [
=>
]
12
Mable Anna Ware
[1.2.3.10.3.1.1.2.3.10.1.3]
b. 30 Jun 1871 d. 11 Jul 1960 [
=>
]
12
Minnie Grace Ware
[1.2.3.10.3.1.1.2.3.10.1.4]
b. 3 Apr 1874 d. 2 Aug 1942
12
Essie May Ware
[1.2.3.10.3.1.1.2.3.10.1.5]
b. 20 Sep 1876 d. 24 Feb 1943 [
=>
]
12
Stella Maude Ware
[1.2.3.10.3.1.1.2.3.10.1.6]
b. 18 Apr 1882 d. 17 Apr 1978 [
=>
]
12
Lora Lucille Ware
[1.2.3.10.3.1.1.2.3.10.1.7]
b. 2 Aug 1886 d. 28 Mar 1958
12
Ruth Adell Ware
[1.2.3.10.3.1.1.2.3.10.1.8]
b. 21 Dec 1889 d. 18 Nov 1983 [
=>
]
9
Mary Polly Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.4]
b. 13 May 1772
Ebeneser Frye
b. 15 Apr 1771 d. Dec 1822
10
Ebenezer Frye
[1.2.3.10.3.1.1.2.4.1]
b. 1795 d. 4 Apr 1823
10
Jedediah Frye
[1.2.3.10.3.1.1.2.4.2]
b. 1797 d. 1817
10
Elizabeth Frye
[1.2.3.10.3.1.1.2.4.3]
b. 1799 d. 1814
10
John B Frye
[1.2.3.10.3.1.1.2.4.4]
b. 14 Apr 1803 d. 18 Oct 1879
Hannah Blake
b. Abt 1807
11
Mary Elizabeth Frye
[1.2.3.10.3.1.1.2.4.4.1]
b. 5 Nov 1830 d. 13 Dec 1855
11
Moses Blake Frye
[1.2.3.10.3.1.1.2.4.4.2]
b. 9 Aug 1832 d. 13 May 1858
11
Huldah Frye
[1.2.3.10.3.1.1.2.4.4.3]
b. 14 Oct 1834
11
Hannah Frye
[1.2.3.10.3.1.1.2.4.4.4]
b. 24 Aug 1837 d. 13 Dec 1855
11
Eben Frye
[1.2.3.10.3.1.1.2.4.4.5]
b. 22 Nov 1838
11
Lucy Frye
[1.2.3.10.3.1.1.2.4.4.6]
b. 29 Aug 1842
Freeman A Wentworth
b. 28 Aug 1838
12
Huldah E Wentworth
[1.2.3.10.3.1.1.2.4.4.6.1]
b. 13 Jul 1863
12
William H Wentworth
[1.2.3.10.3.1.1.2.4.4.6.2]
b. 24 Dec 1866
12
John Wesley Wentworth
[1.2.3.10.3.1.1.2.4.4.6.3]
b. 24 May 1869
11
Calista C Frye
[1.2.3.10.3.1.1.2.4.4.7]
b. 28 May 1845
James A Sproul
b. 1840
12
Sutie Belle Sproul
[1.2.3.10.3.1.1.2.4.4.7.1]
b. 1878
12
Geneva Pearl Sproul
[1.2.3.10.3.1.1.2.4.4.7.2]
b. 1880
11
Robie Frye
[1.2.3.10.3.1.1.2.4.4.8]
b. 18 Jun 1848
10
Nancy R Frye
[1.2.3.10.3.1.1.2.4.5]
b. 1805
William G Whitney
b. Abt 1801
11
James K Whitney
[1.2.3.10.3.1.1.2.4.5.1]
b. 1836
11
Joseph G Whitney
[1.2.3.10.3.1.1.2.4.5.2]
b. 1838 d. 14 Dec 1879
11
Susan Maria Whitney
[1.2.3.10.3.1.1.2.4.5.3]
b. 1841
+
James William Moore
b. 14 Jan 1840 d. 11 Dec 1910
10
Hulda E Frye
[1.2.3.10.3.1.1.2.4.6]
b. 12 Jun 1807
9
Abner Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.5]
b. 26 Jan 1775 d. 14 Jul 1865
Polly Robertson
b. 15 Dec 1778
10
Mahala Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.5.1]
b. 11 Nov 1802
Aaron Critchett
b. Abt 26 Jan 1800 d. 28 Aug 1887
11
Susan Jane Critchett
[1.2.3.10.3.1.1.2.5.1.1]
b. 11 Mar 1831
Simonds Fowles Phelps
b. 17 Mar 1834
12
George Hovey Phelps
[1.2.3.10.3.1.1.2.5.1.1.1]
b. 17 Jul 1862 [
=>
]
12
Ida Bell Phelps
[1.2.3.10.3.1.1.2.5.1.1.2]
b. 16 Jun 1866
11
Charles E Critchett
[1.2.3.10.3.1.1.2.5.1.2]
b. 1835 d. 23 Jun 1902
+
Annie McDonald
b. 3 Jan 1841 d. 1 Jan 1905
10
Harriet Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.5.2]
b. 7 Jul 1805 d. 9 Dec 1883
John Kimball
b. 16 Feb 1807 d. 9 Dec 1883
11
Charles Kimball
[1.2.3.10.3.1.1.2.5.2.1]
b. 25 Jan 1830 d. 1 Sep 1884
11
Melissia Ann Kimball
[1.2.3.10.3.1.1.2.5.2.2]
b. 10 Sep 1832 d. 3 Aug 1875
+
Dudley H Robinson
b. 1830
11
Harriet Augusta Kimball
[1.2.3.10.3.1.1.2.5.2.3]
b. 20 Dec 1836 d. 17 Oct 1885
+
Moore
b. 1834
11
John Noyes Kimball
[1.2.3.10.3.1.1.2.5.2.4]
b. 9 Sep 1845 d. 7 Aug 1890
Acenath P Matthews
b. 17 Sep 1855 d. 7 Jun 1913
12
Edith Estelle Kimball
[1.2.3.10.3.1.1.2.5.2.4.1]
b. 7 Dec 1877 d. 17 Jan 1971 [
=>
]
12
John Charles Kimball
[1.2.3.10.3.1.1.2.5.2.4.2]
b. 13 Jun 1879 d. 19 Dec 1915
12
Arthur Kimball
[1.2.3.10.3.1.1.2.5.2.4.3]
b. 1881 d. 1965
12
Bessie Mae Kimball
[1.2.3.10.3.1.1.2.5.2.4.4]
b. 28 Apr 1885 d. 30 Apr 1970 [
=>
]
12
Ray Kimball
[1.2.3.10.3.1.1.2.5.2.4.5]
b. 22 Jul 1888 d. 11 Nov 1948
11
Sarah Jane Kimball
[1.2.3.10.3.1.1.2.5.2.5]
b. 20 Oct 1847
+
Ezra G Colcord
b. 1845
10
Albert Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.5.3]
b. 3 Dec 1806 d. 7 Oct 1892
Esther Williams
d. 13 Jul 1889
11
Eudora F Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.5.3.1]
b. 1846 d. 30 Oct 1868
11
Mary Esther Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.5.3.2]
b. 1868 d. 1870
10
Margaret Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.5.4]
b. 14 Oct 1808 d. 3 Mar 1895
William Morgan
b. 17 Apr 1812 d. 18 May 1860
11
Warren Morgan
[1.2.3.10.3.1.1.2.5.4.1]
b. 18 Apr 1838 d. 9 Feb 1904
11
Harriett A Morgan
[1.2.3.10.3.1.1.2.5.4.2]
b. 8 Mar 1841
11
Edmund R Morgan
[1.2.3.10.3.1.1.2.5.4.3]
b. 6 Mar 1843
11
William Morgan
[1.2.3.10.3.1.1.2.5.4.4]
b. 28 Mar 1846
11
Emily Morgan
[1.2.3.10.3.1.1.2.5.4.5]
b. 6 Jul 1847 d. 1 Sep 1868
11
Mary J Morgan
[1.2.3.10.3.1.1.2.5.4.6]
b. 26 Jul 1850
11
Ella Morgan
[1.2.3.10.3.1.1.2.5.4.7]
b. 8 Apr 1859
10
John Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.5.5]
b. Abt 1813
10
Nealy Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.5.6]
b. 27 Aug 1817
9
Martha Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.6]
b. Abt 1776 d. 25 Apr 1868
Jedediah Holt
b. 12 Aug 1774 d. 1850
10
Lucinda Holt
[1.2.3.10.3.1.1.2.6.1]
b. 18 May 1805
Warren Flint
b. Abt 1803
11
Tamar Flint
[1.2.3.10.3.1.1.2.6.1.1]
b. Abt 1826 d. 6 Mar 1833
11
Warren Byron Flint
[1.2.3.10.3.1.1.2.6.1.2]
b. 25 Mar 1831
11
Alvan Sawyer Flint
[1.2.3.10.3.1.1.2.6.1.3]
b. 15 Dec 1832
11
Lucy Sawyer Flint
[1.2.3.10.3.1.1.2.6.1.4]
b. 9 Sep 1834
+
Butler
b. 1830
11
George Henry Flint
[1.2.3.10.3.1.1.2.6.1.5]
b. 22 Aug 1836 d. 10 Jul 1905
Ellen Tamar Pinks
b. 6 Nov 1836 d. 3 Apr 1909
12
Marion Louise Flint
[1.2.3.10.3.1.1.2.6.1.5.1]
b. 22 Aug 1874 d. 28 Dec 1917 [
=>
]
12
Georgiana Chapin Flint
[1.2.3.10.3.1.1.2.6.1.5.2]
b. 24 Jul 1876 [
=>
]
12
Clifford Henry Flint
[1.2.3.10.3.1.1.2.6.1.5.3]
b. 23 Feb 1882
11
Benjamin Franklin Flint
[1.2.3.10.3.1.1.2.6.1.6]
b. 1 Jul 1838
+
Jennie Fidelia Andrews
b. 25 Mar 1854
11
Forest Newton Flint
[1.2.3.10.3.1.1.2.6.1.7]
b. 13 Jan 1842
11
Ellen Viola Flint
[1.2.3.10.3.1.1.2.6.1.8]
b. 12 Feb 1844
11
Viola M Flint
[1.2.3.10.3.1.1.2.6.1.9]
b. 6 Dec 1850
10
Mary Holt
[1.2.3.10.3.1.1.2.6.2]
b. 18 May 1805
Joshua Burley
b. 28 Mar 1803
11
Mary J Burley
[1.2.3.10.3.1.1.2.6.2.1]
b. 10 Dec 1827 d. 15 Sep 1904
Wyman Pattee
b. 26 Aug 1826 d. 9 Mar 1902
12
Edward B Pattee
[1.2.3.10.3.1.1.2.6.2.1.1]
b. 26 Feb 1860 d. 23 Feb 1863
12
James Wyman Pattee
[1.2.3.10.3.1.1.2.6.2.1.2]
b. 27 Jul 1864 d. 24 Mar 1951 [
=>
]
12
John Holt Pattee
[1.2.3.10.3.1.1.2.6.2.1.3]
b. 23 Dec 1867 [
=>
]
11
Elizabeth Burley
[1.2.3.10.3.1.1.2.6.2.2]
b. 1832
11
William F Burley
[1.2.3.10.3.1.1.2.6.2.3]
b. 1841
11
Emma A Burley
[1.2.3.10.3.1.1.2.6.2.4]
b. Feb 1846
William Fullmer Eshbach
b. 7 Feb 1842
12
Emma A Eshbach
[1.2.3.10.3.1.1.2.6.2.4.1]
b. 6 Oct 1869 d. 29 Mar 1905 [
=>
]
12
Lois E Eshbach
[1.2.3.10.3.1.1.2.6.2.4.2]
b. 1878
12
Ralph W Eshbach
[1.2.3.10.3.1.1.2.6.2.4.3]
b. 1882
11
Ella M Burley
[1.2.3.10.3.1.1.2.6.2.5]
b. 6 Apr 1848
Cloud Harvey Brock
b. 19 Aug 1842
12
Frank M Brock
[1.2.3.10.3.1.1.2.6.2.5.1]
b. 2 Dec 1867 d. 7 Feb 1874
12
George H Brock
[1.2.3.10.3.1.1.2.6.2.5.2]
b. 27 Jan 1870 d. 14 Oct 1950 [
=>
]
12
Carrie M Brock
[1.2.3.10.3.1.1.2.6.2.5.3]
b. 18 Jun 1871 d. 19 Sep 1871
12
Idella May Brock
[1.2.3.10.3.1.1.2.6.2.5.4]
b. 5 Sep 1876 [
=>
]
11
George J Burley
[1.2.3.10.3.1.1.2.6.2.6]
b. 1851
10
Son Holt
[1.2.3.10.3.1.1.2.6.3]
b. Abt 1810
10
Daniel Holt
[1.2.3.10.3.1.1.2.6.4]
b. 15 Jun 1815 d. 15 Aug 1873
Sarah A Sanborn
b. 1 Jun 1813
11
Francis B Holt
[1.2.3.10.3.1.1.2.6.4.1]
b. Jun 1837
11
Lizzie Holt
[1.2.3.10.3.1.1.2.6.4.2]
b. 1839
11
George W Holt
[1.2.3.10.3.1.1.2.6.4.3]
b. Feb 1842
11
Charles Albert Holt
[1.2.3.10.3.1.1.2.6.4.4]
b. 20 Mar 1848
11
Josephine A Holt
[1.2.3.10.3.1.1.2.6.4.5]
b. 29 Mar 1851 d. 18 Apr 1858
10
John Holt
[1.2.3.10.3.1.1.2.6.5]
b. 26 Dec 1812 d. Aft 1861
Letitia Blanchard
b. 1814
11
Esther J Holt
[1.2.3.10.3.1.1.2.6.5.1]
b. 29 Nov 1848
11
Ann Jennette Holt
[1.2.3.10.3.1.1.2.6.5.2]
b. Oct 1858
10
Franklin Holt
[1.2.3.10.3.1.1.2.6.6]
b. 8 Jan 1818 d. Aft 1861
Eliza Sanborn
b. Abt 1820 d. 5 Dec 1880
11
Henry Harrison Holt
[1.2.3.10.3.1.1.2.6.6.1]
b. 28 Feb 1843
+
Martha A Warren
b. 6 Mar 1845 d. Abt 1928
11
John F Holt
[1.2.3.10.3.1.1.2.6.6.2]
b. 15 Jan 1848 d. 29 Jan 1848
11
Ellen M Holt
[1.2.3.10.3.1.1.2.6.6.3]
b. 18 May 1850
11
Son Holt
[1.2.3.10.3.1.1.2.6.6.4]
b. 5 May 1852
11
Lafayette Holt
[1.2.3.10.3.1.1.2.6.6.5]
b. 2 Sep 1855
9
Jacob Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.7]
b. 6 Jun 1777
+
Polly Colby
b. 1780
9
Nancy Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.8]
b. 29 Jun 1779
John Robertson
b. Abt 1777
10
Nancy Robertson
[1.2.3.10.3.1.1.2.8.1]
b. 22 Dec 1808 d. 8 Mar 1877
Samuel Dakin
b. 23 May 1812 d. 31 Aug 1844
11
John Robertson Dakin
[1.2.3.10.3.1.1.2.8.1.1]
b. 19 Jul 1843
9
Isaac Chamberlain Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9]
b. 28 Nov 1781 d. 12 May 1860
Polly Noyes
b. Abt 1782 d. 25 Apr 1841
10
George W Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.1]
b. 25 Jan 1805 d. 7 Jun 1874
Caroline Avery
b. Abt 1805
11
Isaac D Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.1.1]
b. 16 Jul 1826
Clarissa Cameron
b. 1828
12
Clara Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.1.1.1]
b. 1850
12
Charles Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.1.1.2]
b. 1854
12
Elizabeth Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.1.1.3]
b. 1859
12
William C Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.1.1.4]
b. Apr 1862 [
=>
]
12
Hannah Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.1.1.5]
b. 22 Oct 1865
12
Lydia Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.1.1.6]
b. 22 Oct 1865
11
George W Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.1.2]
b. 7 Jun 1828 d. 27 Oct 1857
Isabel Stewart
b. Abt 1831
12
William S Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.1.2.1]
b. 22 Nov 1853 [
=>
]
12
May L Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.1.2.2]
b. 16 Jul 1855
11
Caroline Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.1.3]
b. 27 Feb 1830 d. 24 Feb 1860
11
Hannah Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.1.4]
b. 18 May 1833 d. 26 Apr 1860
11
Thomas Alonzo Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.1.5]
b. 18 Nov 1837 d. 2 Aug 1923
Susan E Young
b. 4 Jun 1843 d. 27 Mar 1936
12
Caroline Estell Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.1.5.1]
b. 18 Aug 1862 d. 12 Sep 1901 [
=>
]
12
Alonzo L Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.1.5.2]
b. 14 Jul 1864 d. 1928 [
=>
]
12
Alberta F Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.1.5.3]
b. 24 Aug 1867 d. 3 Oct 1943 [
=>
]
12
Angie Sarah Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.1.5.4]
b. 15 Aug 1869 [
=>
]
12
Alice P Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.1.5.5]
b. 3 Nov 1874 d. 10 Feb 1903
12
George E Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.1.5.6]
b. 14 Apr 1877 d. 2 Feb
12
Viola E Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.1.5.7]
b. 4 Aug 1879 d. 28 Nov 1965
12
Eugene L Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.1.5.8]
b. 20 Aug 1882 d. 18 Nov 1961
12
Sarah A Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.1.5.9]
b. Abt 1884
12
Guy Almond Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.1.5.10]
b. 2 May 1885 d. 21 Sep 1887
12
Tennie Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.1.5.11]
b. Abt 1887
11
John Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.1.6]
b. 9 Apr 1841 d. 21 Sep 1879
11
Olive Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.1.7]
b. 31 Jul 1843 d. Feb 1878
11
Dennis S Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.1.8]
b. 1 Nov 1852 d. 4 Dec 1865
10
Edwin Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.2]
b. 9 Nov 1806 d. 1894
+
Sophie Richards
10
Mary N Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.3]
b. 18 Jan 1809 d. 2 Apr 1900
Thomas Adams
c. 25 Aug 1806 d. 29 Apr 1875
11
Sophronia Adams
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.3.1]
b. 1836
George Henry Alger
b. 7 Mar 1835 d. 1 Jul 1878
12
Son Alger
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.3.1.1]
b. 19 Sep 1857
12
Sarah M Alger
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.3.1.2]
b. 1858
12
Mary Lillie Alger
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.3.1.3]
b. 18 Jul 1860 d. 15 Aug 1863
12
Lola M Alger
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.3.1.4]
b. 27 May 1867 d. 20 Jul 1867
12
Lulu E Alger
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.3.1.5]
b. 20 Dec 1869
11
Edwin L Adams
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.3.2]
b. 1840
+
Ellen Ryan
11
Melissa L Adams
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.3.3]
b. 1842
+
Leander J Owen
b. 1834
Joseph Ashley
b. 1833 d. 1900
12
Winifred M Ashley
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.3.3.1]
b. 14 May 1876
12
Nina Maude Ashley
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.3.3.2]
b. 1880
11
Silvia J Adams
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.3.4]
b. 1845
Elbridge Gerry May
b. 8 Feb 1833 d. 28 Nov 1908
12
Ida M May
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.3.4.1]
b. 10 Jan 1872 d. 11 May 1905 [
=>
]
12
Lillie Josephine May
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.3.4.2]
b. 15 Oct 1877 d. Aft 1900
11
Melvina Adams
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.3.5]
b. 19 Jul 1849 d. 30 Apr 1912
Augustus Sarsfield
b. 1854
12
Myron W Sansfield
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.3.5.1]
b. 27 Mar 1878
11
Melvin Adams
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.3.6]
b. 1852
+
Caroline Mary Wheeler
Sarah W Chapman
b. 19 Dec 1852 d. 20 Aug 1905
12
Arthur Melvin Adams
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.3.6.1]
b. 7 Jun 1877
12
Mary E Adams
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.3.6.2]
b. 1879
12
Eva Georgia Adams
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.3.6.3]
b. 26 Jun 1882
12
Laura Emma Adams
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.3.6.4]
b. 8 Oct 1885
+
Belle Marie Shaw Leavitt
b. 1852
10
Louisa Noves
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.4]
b. 14 Mar 1811 d. 1876
William Deane
b. 26 Mar 1801
11
Mary Gibbs Deane
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.4.1]
b. 15 Aug 1830
Howard Winslow Talcott
b. 16 Jun 1831
12
William Dean Talcott
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.4.1.1]
b. 20 May 1858 [
=>
]
12
Fred Howard Talcott
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.4.1.2]
b. 24 Apr 1864
11
Cyrus Deane
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.4.2]
b. 9 Mar 1834 d. 17 Dec 1908
Fanny Newell Staples
b. 24 Oct 1833 d. 16 Apr 1873
12
Mary Jane Deane
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.4.2.1]
b. 5 Aug 1859
12
Olive Matilda Dean
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.4.2.2]
b. 11 Jun 1862
12
Anna Luella Deane
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.4.2.3]
b. 1 Jun 1864
12
John Franklin Deane
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.4.2.4]
b. 23 Feb 1869
12
Howard Cyrus Deane
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.4.2.5]
b. 6 Apr 1873
Susan Augusta Pratt
b. 1843 d. 7 Jul 1908
12
Ethel Almeda Deane
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.4.2.6]
b. 3 Apr 1880 d. 25 Mar 1943 [
=>
]
12
Edward Nathaniel Deane
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.4.2.7]
b. 30 Mar 1882
12
Stephen W Deane
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.4.2.8]
b. 1888
11
William Penn Deane
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.4.3]
b. 24 Jul 1842
Olive Woodman Chase
b. 10 Mar 1852
12
Flora E Deane
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.4.3.1]
b. Nov 1883
+
Callie W Fales
b. Feb 1857
11
Louisa Matilda Deane
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.4.4]
b. 4 Jul 1846 d. Aft 1873
Joel Dunlap
b. 1835 d. Aft 1873
12
Ella Louisa Dunlap
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.4.4.1]
b. 25 Oct 1872
12
Ephraine Dunlap
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.4.4.2]
b. 1874
12
Clarence J Dunlap
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.4.4.3]
b. 25 Apr 1888 d. 25 Nov 1981 [
=>
]
11
Alma Llewella Deane
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.4.5]
b. 7 Feb 1852
10
Delia Adams Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.5]
b. 10 Sep 1813
Joseph Avery
b. 1810
11
Adelia E Avery
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.5.1]
b. 12 May 1834
+
George W Morse
b. Oct 1833
10
Rachel Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.6]
b. Abt 1817 d. 1838
10
Isaac C Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.7]
b. 27 Oct 1819 d. 12 Aug 1891
10
Nancy J Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.8]
b. 15 Jan 1823
10
Sophronia G Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.9]
b. 15 Jan 1824 d. 1871
Charles M Lufkin
b. 15 Jun 1824 d. 31 Aug 1906
11
Ellen Lufkin
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.9.1]
b. Abt 1850
11
Horace Greeley Lufkin
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.9.2]
b. Abt 1853
11
Charles Forrest Lufkin
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.9.3]
b. Aug 1857
Martha Hall
b. Abt 1864
12
Carl Hall Lufkin
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.9.3.1]
b. 27 Feb 1883 d. 18 Mar 1956
12
Lena Lufkin
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.9.3.2]
b. 19 Oct 1883 d. 1924
12
John Logan Lufkin
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.9.3.3]
b. 26 Jan 1886 d. May 1965
11
Adela "Adda" Lufkin
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.9.4]
b. Abt 1858 d. Abt 1882
11
Lucien S Lufkin
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.9.5]
b. Abt 1861 d. 1863
11
Fannie E Lufkin
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.9.6]
b. Abt 1862 d. 1863
10
Sarah N Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.10]
b. 15 Jan 1826 d. 1905
10
Francis Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.11]
b. 27 Oct 1828 d. 1828
10
Franklin Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.12]
b. 14 May 1829 d. 8 Nov 1896
10
Abigail M Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.13]
b. 1 Jun 1831
10
Charles Morse Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.14]
b. 1 Jun 1831 d. 6 Mar 1921
Helen Elizabeth Greenough
b. 17 Jan 1838 d. 5 Jun 1890
11
Harold Verne Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.14.1]
b. 1859 d. 1909
Susan Clark
b. Abt 1863
12
Helen M Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.14.1.1]
b. Abt 1885
11
Franklin Florence Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.14.2]
b. 23 Apr 1861 d. 1935
Eliza R Noyes
b. 29 Oct 1862
12
Erlan S Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.14.2.1]
b. 4 Apr 1884
12
Earlon Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.14.2.2]
b. Abt 1887
12
Lucille A Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.14.2.3]
b. 25 May 1888
Ethel Isabel Mosher
b. 18 Aug 1881 d. 1961
12
Carleton Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.14.2.4]
b. Abt 1887
11
Charles Warren Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.14.3]
b. 22 Dec 1863 d. 25 Apr 1947
Araminta Lois Chase
b. 6 May 1867 d. 18 Dec 1936
12
Harold Greenough Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.14.3.1]
b. 18 Mar 1891 d. 12 May 1960 [
=>
]
12
Clifford Elwin Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.14.3.2]
b. 18 Sep 1893 d. 12 Oct 1989
12
Lena Elizabeth Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.14.3.3]
b. 4 Nov 1894 d. 4 Mar 1993
12
Amy Theodosia Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.14.3.4]
b. 29 Mar 1896 d. 28 Feb 1980
12
Lauriston Franklin Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.14.3.5]
b. 7 Aug 1898 d. 17 Oct 1989
11
Annie R Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.14.4]
b. Nov 1868 d. 12 Apr 1870
11
Lena Estelle Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.14.5]
b. 1872 d. 8 Mar 1875
11
Clifford Greenough Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.14.6]
b. 18 Oct 1875 d. 5 Oct 1883
10
Flavilla P Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.15]
b. 8 Aug 1833 d. 1901
10
Philander E Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.16]
b. 3 Nov 1835
Elvira M Small
b. 1840
11
John R Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.16.1]
b. 8 Jan 1867 d. 26 Jan 1892
11
Alice L Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.16.2]
b. 7 Mar 1869
11
Florence E Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.16.3]
b. 14 Dec 1870
Lucinda J Huse
b. 1864
11
Reno P Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.16.4]
b. 3 Nov 1890
10
Julia A Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.9.17]
b. 8 Feb 1839 d. 1928
+
William W Jones
b. 1829 d. 1909
9
George Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.10]
b. 15 Feb 1784 d. 1888
Hannah Cotton
b. 2 Feb 1791 d. 13 Oct 1877
10
Thomas Branch Cotton Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.10.1]
b. 3 Jul 1809 d. 18 Mar 1833
10
Frances C Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.10.2]
b. 11 May 1811 d. 1840
10
Nancy Cotton Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.10.3]
b. 27 Feb 1823
+
Lowell Eastman
b. 7 Jan 1817
9
Polly B Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.2.11]
b. 28 Mar 1787
+
Jedediah Holt
b. 1781
8
Samuel Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3]
b. 2 Jul 1746 d. 14 Mar 1812
Hannah Bradley
b. 12 Jul 1742
9
Hannah Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.1]
b. 21 May 1770 d. 5 Sep 1856
+
Robert Lake
9
Lois Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.2]
b. 29 May 1772 d. 2 May 1841
Joshua King
b. 7 Oct 1771 d. 28 Sep 1865
10
Nathaniel King
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.1]
b. 5 Nov 1794 d. 14 Feb 1869
Almira Bean
b. 9 Oct 1801 d. 19 Sep 1892
11
Louisa King
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.1.1]
b. 21 Nov 1821 d. 23 Dec 1821
11
George Washington King
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.1.2]
b. Feb 1822 d. 4 Apr 1822
11
Samuel King
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.1.3]
b. 24 Nov 1824 d. 1905
Hannah Clough
b. 9 May 1824 d. 5 Oct 1877
12
Lorenzo Elijah King
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.1.3.1]
b. 27 Feb 1853 d. 10 Sep 1912 [
=>
]
12
Frank King
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.1.3.2]
b. 27 Oct 1853 d. 29 Dec 1942 [
=>
]
12
Ezra King
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.1.3.3]
b. Abt 1856
12
Maria King
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.1.3.4]
b. 8 Nov 1863 d. 1 Apr 1912 [
=>
]
12
Mark King
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.1.3.5]
b. 26 Nov 1868 d. 1 Dec 1934 [
=>
]
11
Son King
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.1.4]
b. Abt 1826
11
Mary Louisa King
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.1.5]
b. 11 Feb 1827 d. 26 Apr 1833
11
Royal King
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.1.6]
b. 9 Nov 1837
11
George D King
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.1.7]
b. 13 Nov 1839 d. 1892
Hester Ann Drew
b. 12 May 1846 d. 22 Jan 1912
12
Gertrude Cornelia King
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.1.7.1]
b. 12 May 1864 d. 14 Dec 1948 [
=>
]
12
Riley Herbert King
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.1.7.2]
b. 1866 d. 1915 [
=>
]
12
Henry King
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.1.7.3]
b. 1868
12
Miner W King
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.1.7.4]
b. 20 Jan 1870
12
Orson King
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.1.7.5]
b. 5 Oct 1871
12
Arthur King
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.1.7.6]
b. 1874
12
Earl A King
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.1.7.7]
b. 29 Mar 1875
12
Royal George King
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.1.7.8]
b. 1877 [
=>
]
12
William Martin King
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.1.7.9]
b. 13 Jan 1879
12
Benjamin J King
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.1.7.10]
b. Feb 1881
12
Mary King
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.1.7.11]
11
Abigail King
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.1.8]
b. 22 Aug 1841
10
Samuel King
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.2]
b. 18 Feb 1796
10
Hannah King
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.3]
b. 12 Feb 1798 d. 5 Dec 1839
10
Sally King
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.4]
b. 9 Jan 1800
10
Aseneth B King
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.5]
b. 25 Oct 1801
+
Ebenezer Ormsby
b. Abt 1794 d. Sep 1850
10
Lois King
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.6]
b. 15 Mar 1804 d. 3 Mar 1877
Elias Smith Tuttle
b. 29 Jul 1808 d. 23 Mar 1894
11
Daughter Tuttle
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.6.1]
b. 1834
11
Son Tuttle
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.6.2]
b. 1834
11
Elias Jefferson Tuttle
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.6.3]
b. 28 Aug 1836
+
Mary A Sargent
b. 21 Jul 1838 d. 1883
+
Randilla F Brown
b. 16 May 1836 d. 7 Aug 1888
+
Dora D Webster
b. 20 Oct 1865
11
Mary Ann Tuttle
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.6.4]
b. 28 Apr 1840
+
Owen F O'Malley
b. 1834 d. 29 Oct 1880
11
George L Tuttle
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.6.5]
b. 8 Aug 1844 d. 9 Nov 1915
+
Helen L Bedell
b. Abt 1849
Eunice Emeline King
b. 1845 d. 19 Nov 1890
12
Herman E Tuttle
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.6.5.1]
b. 24 Dec 1870 d. 2 Jun 1896 [
=>
]
10
James King
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.7]
b. 22 Aug 1806
10
John King
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.8]
b. Abt 1807 d. 21 Sep 1878
Elizabeth M Noyes
b. 21 Dec 1812 d. 23 Dec 1891
11
Lois Cordelia King
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.8.1]
b. 12 Jul 1835
John Ballou
b. 12 Aug 1828
12
Milton John Ballou
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.8.1.1]
b. 6 Jun 1868 d. 1949 [
=>
]
11
Milton J King
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.8.2]
b. 10 May 1839 d. 23 Jun 1867
Etta Watkins
b. 1847
12
Milton John King
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.8.2.1]
b. 3 Jun 1867 d. 16 Dec 1949
11
Lura A King
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.8.3]
b. 20 Apr 1841 d. 11 Apr 1933
Stillman Amasa Dean
b. 1836 d. 10 Sep 1911
12
Albert Milton Dean
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.8.3.1]
b. 5 Dec 1862 d. 1941 [
=>
]
11
Almon L King
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.8.4]
b. Abt 1843
11
David C King
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.8.5]
b. 10 Mar 1847 d. 4 Apr 1925
Harriet M "Hattie" Dean
b. Abt 1846
12
Alonzo Herman King
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.8.5.1]
b. 1 May 1868 d. 12 May 1894 [
=>
]
Susan Ella Knight
b. 1855
12
Paul Dudley King
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.8.5.2]
b. 28 May 1891 d. 11 Oct 1975 [
=>
]
11
Aaron B King
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.8.6]
b. Abt 1849
10
Mary King
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.9]
b. 12 Jul 1810
10
Moses King
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.10]
b. 7 Aug 1812
10
Abigail King
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.11]
b. 3 Oct 1815
10
Nancy Chambers King
[1.2.3.10.3.1.1.3.2.12]
b. 18 Sep 1818
9
Nathaniel Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.3]
b. 26 Jul 1774
Catherine Dean
b. 19 Dec 1775 d. 13 Jan 1859
10
Hannah Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.3.1]
b. 13 Jul 1800 d. 6 Oct 1801
10
Otis Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.3.2]
b. 18 Aug 1802 d. 23 Jun 1878
Nancy G Cummings
b. Abt 1802 d. 16 Sep 1874
11
Henry Otis Moyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.3.2.1]
b. 29 Jan 1826 d. 10 May 1869
Angenetta Cleveland
b. 7 Feb 1826 d. 19 Sep 1869
12
Henry Anthony Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.3.2.1.1]
b. 31 Aug 1849 d. 9 Dec 1852
12
Fannie Jenette Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.3.2.1.2]
b. 17 Dec 1850
12
Walter Wayne Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.3.2.1.3]
b. 5 Jun 1854
12
Angia Luella Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.3.2.1.4]
b. 9 Jun 1856 d. 24 Jun 1877
12
Laura Louisa Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.3.2.1.5]
b. 16 Jun 1860 d. 9 Sep 1862
12
Cora Pratt Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.3.2.1.6]
b. 15 May 1862 d. 15 Sep 1862
12
Emily Louisa Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.3.2.1.7]
b. 3 Aug 1864 d. 10 Nov 1880
12
Charles Henry Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.3.2.1.8]
b. 17 Aug 1867 d. 16 Jan 1869
11
Nancy J Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.3.2.2]
b. Abt 1827
Edmund W Lyons
12
Edmund N Lyons
[1.2.3.10.3.1.1.3.3.2.2.1]
b. 26 Jan 1859
12
Annie Mabel Lyons
[1.2.3.10.3.1.1.3.3.2.2.2]
b. 25 Aug 1863
11
Son Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.3.2.3]
b. 1828
10
Hannah Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.3.3]
b. 17 Mar 1805 d. 31 Oct 1823
10
Elizabeth Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.3.4]
b. 11 Dec 1807 d. 1881
Joel Metcalf Baker
b. 9 Sep 1808 d. 21 May 1878
11
Francis Metcalf Baker
[1.2.3.10.3.1.1.3.3.4.1]
b. 7 May 1833
Sarah Elizabeth Morse
b. 21 Feb 1833
12
Fanny Elizabeth Baker
[1.2.3.10.3.1.1.3.3.4.1.1]
b. 28 Dec 1858
12
William F Baker
[1.2.3.10.3.1.1.3.3.4.1.2]
b. 16 Dec 1862
11
Henry Bradford Baker
[1.2.3.10.3.1.1.3.3.4.2]
b. 9 Jan 1838
+
Ellen L Savels
b. 9 Dec 1841
11
Ellen Elizabeth Baker
[1.2.3.10.3.1.1.3.3.4.3]
b. 15 Jan 1848
+
Samuel C Lovis
b. Abt 1846
10
Nathaniel Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.3.5]
b. 10 Feb 1810 d. 12 Nov 1889
+
Sarah Draper
b. 1 Jul 1809 d. 10 Nov 1831
10
Catharine Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.3.6]
b. 20 Dec 1812 d. 1876
10
Mary Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.3.7]
b. 6 Jun 1815 d. 1892
+
Edwin B Knight
b. 1813
10
Lucy Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.3.8]
b. 28 Jan 1818 d. 1856
+
Marcus A Jackson
b. 1816
9
Betsey Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.4]
b. 27 Nov 1775
9
John Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.5]
b. 8 Dec 1777
9
Polly Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6]
b. Abt 1782 d. 25 Apr 1841
Isaac Chamberlain Noyes
b. 28 Nov 1781 d. 12 May 1860
10
George W Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.1]
b. 25 Jan 1805 d. 7 Jun 1874
Caroline Avery
b. Abt 1805
11
Isaac D Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.1.1]
b. 16 Jul 1826
Clarissa Cameron
b. 1828
12
Clara Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.1.1.1]
b. 1850
12
Charles Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.1.1.2]
b. 1854
12
Elizabeth Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.1.1.3]
b. 1859
12
William C Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.1.1.4]
b. Apr 1862 [
=>
]
12
Hannah Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.1.1.5]
b. 22 Oct 1865
12
Lydia Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.1.1.6]
b. 22 Oct 1865
11
George W Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.1.2]
b. 7 Jun 1828 d. 27 Oct 1857
Isabel Stewart
b. Abt 1831
12
William S Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.1.2.1]
b. 22 Nov 1853 [
=>
]
12
May L Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.1.2.2]
b. 16 Jul 1855
11
Caroline Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.1.3]
b. 27 Feb 1830 d. 24 Feb 1860
11
Hannah Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.1.4]
b. 18 May 1833 d. 26 Apr 1860
11
Thomas Alonzo Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.1.5]
b. 18 Nov 1837 d. 2 Aug 1923
Susan E Young
b. 4 Jun 1843 d. 27 Mar 1936
12
Caroline Estell Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.1.5.1]
b. 18 Aug 1862 d. 12 Sep 1901 [
=>
]
12
Alonzo L Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.1.5.2]
b. 14 Jul 1864 d. 1928 [
=>
]
12
Alberta F Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.1.5.3]
b. 24 Aug 1867 d. 3 Oct 1943 [
=>
]
12
Angie Sarah Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.1.5.4]
b. 15 Aug 1869 [
=>
]
12
Alice P Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.1.5.5]
b. 3 Nov 1874 d. 10 Feb 1903
12
George E Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.1.5.6]
b. 14 Apr 1877 d. 2 Feb
12
Viola E Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.1.5.7]
b. 4 Aug 1879 d. 28 Nov 1965
12
Eugene L Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.1.5.8]
b. 20 Aug 1882 d. 18 Nov 1961
12
Sarah A Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.1.5.9]
b. Abt 1884
12
Guy Almond Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.1.5.10]
b. 2 May 1885 d. 21 Sep 1887
12
Tennie Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.1.5.11]
b. Abt 1887
11
John Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.1.6]
b. 9 Apr 1841 d. 21 Sep 1879
11
Olive Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.1.7]
b. 31 Jul 1843 d. Feb 1878
11
Dennis S Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.1.8]
b. 1 Nov 1852 d. 4 Dec 1865
10
Edwin Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.2]
b. 9 Nov 1806 d. 1894
+
Sophie Richards
10
Mary N Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.3]
b. 18 Jan 1809 d. 2 Apr 1900
Thomas Adams
c. 25 Aug 1806 d. 29 Apr 1875
11
Sophronia Adams
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.3.1]
b. 1836
George Henry Alger
b. 7 Mar 1835 d. 1 Jul 1878
12
Son Alger
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.3.1.1]
b. 19 Sep 1857
12
Sarah M Alger
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.3.1.2]
b. 1858
12
Mary Lillie Alger
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.3.1.3]
b. 18 Jul 1860 d. 15 Aug 1863
12
Lola M Alger
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.3.1.4]
b. 27 May 1867 d. 20 Jul 1867
12
Lulu E Alger
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.3.1.5]
b. 20 Dec 1869
11
Edwin L Adams
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.3.2]
b. 1840
+
Ellen Ryan
11
Melissa L Adams
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.3.3]
b. 1842
+
Leander J Owen
b. 1834
Joseph Ashley
b. 1833 d. 1900
12
Winifred M Ashley
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.3.3.1]
b. 14 May 1876
12
Nina Maude Ashley
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.3.3.2]
b. 1880
11
Silvia J Adams
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.3.4]
b. 1845
Elbridge Gerry May
b. 8 Feb 1833 d. 28 Nov 1908
12
Ida M May
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.3.4.1]
b. 10 Jan 1872 d. 11 May 1905 [
=>
]
12
Lillie Josephine May
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.3.4.2]
b. 15 Oct 1877 d. Aft 1900
11
Melvina Adams
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.3.5]
b. 19 Jul 1849 d. 30 Apr 1912
Augustus Sarsfield
b. 1854
12
Myron W Sansfield
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.3.5.1]
b. 27 Mar 1878
11
Melvin Adams
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.3.6]
b. 1852
+
Caroline Mary Wheeler
Sarah W Chapman
b. 19 Dec 1852 d. 20 Aug 1905
12
Arthur Melvin Adams
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.3.6.1]
b. 7 Jun 1877
12
Mary E Adams
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.3.6.2]
b. 1879
12
Eva Georgia Adams
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.3.6.3]
b. 26 Jun 1882
12
Laura Emma Adams
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.3.6.4]
b. 8 Oct 1885
+
Belle Marie Shaw Leavitt
b. 1852
10
Louisa Noves
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.4]
b. 14 Mar 1811 d. 1876
William Deane
b. 26 Mar 1801
11
Mary Gibbs Deane
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.4.1]
b. 15 Aug 1830
Howard Winslow Talcott
b. 16 Jun 1831
12
William Dean Talcott
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.4.1.1]
b. 20 May 1858 [
=>
]
12
Fred Howard Talcott
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.4.1.2]
b. 24 Apr 1864
11
Cyrus Deane
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.4.2]
b. 9 Mar 1834 d. 17 Dec 1908
Fanny Newell Staples
b. 24 Oct 1833 d. 16 Apr 1873
12
Mary Jane Deane
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.4.2.1]
b. 5 Aug 1859
12
Olive Matilda Dean
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.4.2.2]
b. 11 Jun 1862
12
Anna Luella Deane
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.4.2.3]
b. 1 Jun 1864
12
John Franklin Deane
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.4.2.4]
b. 23 Feb 1869
12
Howard Cyrus Deane
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.4.2.5]
b. 6 Apr 1873
Susan Augusta Pratt
b. 1843 d. 7 Jul 1908
12
Ethel Almeda Deane
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.4.2.6]
b. 3 Apr 1880 d. 25 Mar 1943 [
=>
]
12
Edward Nathaniel Deane
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.4.2.7]
b. 30 Mar 1882
12
Stephen W Deane
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.4.2.8]
b. 1888
11
William Penn Deane
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.4.3]
b. 24 Jul 1842
Olive Woodman Chase
b. 10 Mar 1852
12
Flora E Deane
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.4.3.1]
b. Nov 1883
+
Callie W Fales
b. Feb 1857
11
Louisa Matilda Deane
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.4.4]
b. 4 Jul 1846 d. Aft 1873
Joel Dunlap
b. 1835 d. Aft 1873
12
Ella Louisa Dunlap
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.4.4.1]
b. 25 Oct 1872
12
Ephraine Dunlap
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.4.4.2]
b. 1874
12
Clarence J Dunlap
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.4.4.3]
b. 25 Apr 1888 d. 25 Nov 1981 [
=>
]
11
Alma Llewella Deane
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.4.5]
b. 7 Feb 1852
10
Delia Adams Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.5]
b. 10 Sep 1813
Joseph Avery
b. 1810
11
Adelia E Avery
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.5.1]
b. 12 May 1834
+
George W Morse
b. Oct 1833
10
Rachel Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.6]
b. Abt 1817 d. 1838
10
Isaac C Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.7]
b. 27 Oct 1819 d. 12 Aug 1891
10
Nancy J Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.8]
b. 15 Jan 1823
10
Sophronia G Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.9]
b. 15 Jan 1824 d. 1871
Charles M Lufkin
b. 15 Jun 1824 d. 31 Aug 1906
11
Ellen Lufkin
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.9.1]
b. Abt 1850
11
Horace Greeley Lufkin
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.9.2]
b. Abt 1853
11
Charles Forrest Lufkin
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.9.3]
b. Aug 1857
Martha Hall
b. Abt 1864
12
Carl Hall Lufkin
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.9.3.1]
b. 27 Feb 1883 d. 18 Mar 1956
12
Lena Lufkin
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.9.3.2]
b. 19 Oct 1883 d. 1924
12
John Logan Lufkin
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.9.3.3]
b. 26 Jan 1886 d. May 1965
11
Adela "Adda" Lufkin
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.9.4]
b. Abt 1858 d. Abt 1882
11
Lucien S Lufkin
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.9.5]
b. Abt 1861 d. 1863
11
Fannie E Lufkin
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.9.6]
b. Abt 1862 d. 1863
10
Sarah N Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.10]
b. 15 Jan 1826 d. 1905
10
Francis Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.11]
b. 27 Oct 1828 d. 1828
10
Franklin Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.12]
b. 14 May 1829 d. 8 Nov 1896
10
Abigail M Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.13]
b. 1 Jun 1831
10
Charles Morse Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.14]
b. 1 Jun 1831 d. 6 Mar 1921
Helen Elizabeth Greenough
b. 17 Jan 1838 d. 5 Jun 1890
11
Harold Verne Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.14.1]
b. 1859 d. 1909
Susan Clark
b. Abt 1863
12
Helen M Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.14.1.1]
b. Abt 1885
11
Franklin Florence Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.14.2]
b. 23 Apr 1861 d. 1935
Eliza R Noyes
b. 29 Oct 1862
12
Erlan S Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.14.2.1]
b. 4 Apr 1884
12
Earlon Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.14.2.2]
b. Abt 1887
12
Lucille A Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.14.2.3]
b. 25 May 1888
Ethel Isabel Mosher
b. 18 Aug 1881 d. 1961
12
Carleton Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.14.2.4]
b. Abt 1887
11
Charles Warren Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.14.3]
b. 22 Dec 1863 d. 25 Apr 1947
Araminta Lois Chase
b. 6 May 1867 d. 18 Dec 1936
12
Harold Greenough Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.14.3.1]
b. 18 Mar 1891 d. 12 May 1960 [
=>
]
12
Clifford Elwin Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.14.3.2]
b. 18 Sep 1893 d. 12 Oct 1989
12
Lena Elizabeth Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.14.3.3]
b. 4 Nov 1894 d. 4 Mar 1993
12
Amy Theodosia Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.14.3.4]
b. 29 Mar 1896 d. 28 Feb 1980
12
Lauriston Franklin Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.14.3.5]
b. 7 Aug 1898 d. 17 Oct 1989
11
Annie R Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.14.4]
b. Nov 1868 d. 12 Apr 1870
11
Lena Estelle Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.14.5]
b. 1872 d. 8 Mar 1875
11
Clifford Greenough Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.14.6]
b. 18 Oct 1875 d. 5 Oct 1883
10
Flavilla P Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.15]
b. 8 Aug 1833 d. 1901
10
Philander E Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.16]
b. 3 Nov 1835
Elvira M Small
b. 1840
11
John R Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.16.1]
b. 8 Jan 1867 d. 26 Jan 1892
11
Alice L Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.16.2]
b. 7 Mar 1869
11
Florence E Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.16.3]
b. 14 Dec 1870
Lucinda J Huse
b. 1864
11
Reno P Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.16.4]
b. 3 Nov 1890
10
Julia A Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.6.17]
b. 8 Feb 1839 d. 1928
+
William W Jones
b. 1829 d. 1909
9
Samuel Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.7]
b. Oct 1784 d. 4 Jan 1864
Elisabeth Morill
b. 1785
10
Samuel Bradley Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.7.1]
b. 9 Apr 1817 d. 1900
Georgiana Beaumont
b. 1820
11
Teresa I Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.7.1.1]
b. 9 Aug 1851
+
Charles H French
11
Eliza R Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.7.1.2]
b. 22 Jun 1857
+
Frederick Walter Sumner
b. 29 Oct 1855
11
Bradley M Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.7.1.3]
b. 26 Dec 1864
11
James B Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.7.1.4]
b. 1 Nov 1870
10
Maria Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.7.2]
b. 30 Nov 1819 d. 1850
10
William A Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.7.3]
b. 17 Oct 1820
Abagail Rodgers
11
Emily L Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.7.3.1]
b. 15 Dec 1838
11
Edward E Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.7.3.2]
b. 14 May 1840
Mary Reddington Howe
b. 3 Dec 1824
11
Frances Eliza Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.7.3.3]
b. 7 Apr 1846
11
William Henry Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.7.3.4]
b. 3 Jul 1848
11
Sarah M Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.7.3.5]
b. 7 Oct 1849
11
Isabel A Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.7.3.6]
b. 18 Mar 1853
11
Emma G Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.7.3.7]
b. 5 Nov 1855
Thomas Lyons
b. Nov 1850 d. 17 May 1917
12
Alice Cosette Lyons
[1.2.3.10.3.1.1.3.7.3.7.1]
b. 9 Jan 1877 d. 11 Dec 1961 [
=>
]
10
Elisabeth Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.7.4]
b. 8 Oct 1823
10
Emaline Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.7.5]
b. 5 Jul 1827
10
George L Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.7.6]
b. 5 Apr 1839
Abbie Ordway
b. Abt 1842
11
George William Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.7.6.1]
b. 3 May 1864 d. 7 Jan 1918
11
George WM Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.7.6.2]
b. 3 May 1867
9
David Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.8]
b. 1784 d. 5 Jan 1854
Ruth Fiske
b. 1788
10
Charles L Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.8.1]
b. 1818
Delilah Gutterson
b. 1820
11
Grace Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.8.1.1]
b. 1845
9
Sarah Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.3.9]
b. Abt 1787
+
Thomas Cass
b. 1785
8
Daniel Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4]
b. 24 Nov 1748 d. 13 Jan 1822
Abigail Eames
b. 23 Apr 1758 d. 13 Jan 1824
9
Betsy Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.1]
b. 9 Jan 1778 d. 17 Jul 1843
Moses W Fife
b. 1783 d. 1859
10
Mary Magdalene Fife
[1.2.3.10.3.1.1.4.1.1]
b. 18 Jun 1809 d. 1839
Ira Ames
b. 1803 d. 1865
11
Louisa Ames
[1.2.3.10.3.1.1.4.1.1.1]
b. 1832
11
Betsey Ames
[1.2.3.10.3.1.1.4.1.1.2]
b. 1834
11
Noyes Ames
[1.2.3.10.3.1.1.4.1.1.3]
b. 1838
10
Peter Fife
[1.2.3.10.3.1.1.4.1.2]
b. 15 Jan 1811 d. 13 Mar 1876
+
Louisa R Gordon
b. 3 Apr 1829 d. 9 Apr 1908
10
Betsey Fife
[1.2.3.10.3.1.1.4.1.3]
b. 6 Feb 1812 d. 17 Feb 1884
John Chandler
b. 11 Mar 1807 d. 12 Nov 1892
11
Sophrona W Chandler
[1.2.3.10.3.1.1.4.1.3.1]
b. 10 Feb 1837
+
Hannibal D Grover
b. Abt 1833
11
William Perry Chandler
[1.2.3.10.3.1.1.4.1.3.2]
b. 20 May 1839
+
Adaline Parker
b. Abt 1848
11
Jay Chandler
[1.2.3.10.3.1.1.4.1.3.3]
b. 4 Nov 1841
11
Emma Chandler
[1.2.3.10.3.1.1.4.1.3.4]
b. 5 Dec 1843
Moses W Abbott
b. 17 Jan 1841 d. 22 May 1917
12
Liston Everett Abbott
[1.2.3.10.3.1.1.4.1.3.4.1]
b. 7 Dec 1884 d. 2 Jul 1944
11
Wilson Chandler
[1.2.3.10.3.1.1.4.1.3.5]
b. 13 Mar 1846
+
Josephine Farmington
11
Ellen O Chandler
[1.2.3.10.3.1.1.4.1.3.6]
b. 23 Dec 1851
10
Noyes Fife
[1.2.3.10.3.1.1.4.1.4]
b. 13 Aug 1813 d. 1834
10
William Fife
[1.2.3.10.3.1.1.4.1.5]
b. 7 Apr 1816 d. 17 Feb 1891
Ophelia Gordon
b. 14 Jul 1820 d. 15 Jun 1877
11
Elmore Fife
[1.2.3.10.3.1.1.4.1.5.1]
b. 2 Oct 1842 d. 3 Apr 1917
11
Nelson Fife
[1.2.3.10.3.1.1.4.1.5.2]
b. 13 Dec 1844
11
Orilla Fife
[1.2.3.10.3.1.1.4.1.5.3]
b. Abt 1856 d. 5 Nov 1945
+
Mary D Wiley
b. 9 Oct 1818 d. 16 Sep 1901
10
Moses Fife
[1.2.3.10.3.1.1.4.1.6]
b. 8 Feb 1818 d. 25 Aug 1890
Eliza Wyman
b. 15 Feb 1818 d. 18 May 1908
11
Micajah N Fife
[1.2.3.10.3.1.1.4.1.6.1]
b. 16 Oct 1840 d. 20 Jul 1925
+
Mary F Ames
11
Mary Frances Fife
[1.2.3.10.3.1.1.4.1.6.2]
b. 1844 d. 1931
11
Seth Wyman Fife
[1.2.3.10.3.1.1.4.1.6.3]
b. 10 Dec 1846 d. 15 Jan 1915
11
Sarah Noyes Fife
[1.2.3.10.3.1.1.4.1.6.4]
b. 17 Nov 1854 d. 28 Mar 1922
10
Daniel Fife
[1.2.3.10.3.1.1.4.1.7]
b. 21 Sep 1819 d. 29 Jul 1908
Electra Ann Lowe
b. Abt 1826 d. 20 May 1877
11
Ellen A Fife
[1.2.3.10.3.1.1.4.1.7.1]
b. 3 Dec 1848 d. Abt 1872/1880
+
Nelson J Ireland
b. 10 Dec 1834
11
Edwin Augustus Fife
[1.2.3.10.3.1.1.4.1.7.2]
b. 13 Feb 1850 d. 29 Dec 1925
Hepzibah Parish
b. Dec 1853 d. 15 Jan 1928
12
Everett Wendell Fife
[1.2.3.10.3.1.1.4.1.7.2.1]
b. Oct 1889
12
Ernest W Fife
[1.2.3.10.3.1.1.4.1.7.2.2]
b. Dec 1889
11
Daniel L Fife
[1.2.3.10.3.1.1.4.1.7.3]
b. 28 Aug 1851 d. 2 Jan 1922
+
Mary Powell
b. 1852
11
Gertrude A Fife
[1.2.3.10.3.1.1.4.1.7.4]
b. 13 Jul 1854 d. 24 Oct 1916
Andrew Jackson Smith
b. 1830 d. 27 Aug 1899
12
Guy Andrew Smith
[1.2.3.10.3.1.1.4.1.7.4.1]
b. 15 Jun 1874 d. 7 Oct 1944 [
=>
]
12
Fred Raymond Smith
[1.2.3.10.3.1.1.4.1.7.4.2]
b. 28 Mar 1879 d. 3 Jan 1956 [
=>
]
12
Carlton Clyde Smith
[1.2.3.10.3.1.1.4.1.7.4.3]
b. 7 Jun 1881 d. 17 Dec 1952 [
=>
]
12
Earl Fauntleroy Smith
[1.2.3.10.3.1.1.4.1.7.4.4]
b. 6 Jul 1890 d. 23 Oct 1961
12
Ruth Hazel Smith
[1.2.3.10.3.1.1.4.1.7.4.5]
b. 26 Feb 1892 d. 22 Mar 1977 [
=>
]
11
Ella E Fife
[1.2.3.10.3.1.1.4.1.7.5]
b. 25 Jul 1856 d. 15 Sep 1930
11
Edgar P Fife
[1.2.3.10.3.1.1.4.1.7.6]
b. 7 Oct 1858 d. 24 Mar 1933
+
Alice Rogers
b. 1860
11
Wilson L Fife
[1.2.3.10.3.1.1.4.1.7.7]
b. 17 Sep 1861 d. 4 Mar 1895
Carrie Owens
b. 1862
12
Lovejoy Gordan Fife
[1.2.3.10.3.1.1.4.1.7.7.1]
b. 3 Jan 1895
11
Elmer Fife
[1.2.3.10.3.1.1.4.1.7.8]
b. 28 Jun 1865 d. 1870
10
Mary Fife
[1.2.3.10.3.1.1.4.1.8]
b. 4 Apr 1823
9
Daniel Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.2]
b. 10 Jun 1780
Nancy Davis
b. 14 Jun 1789
10
Daniel Davis Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.2.1]
b. 7 May 1822 d. 29 Dec 1893
Mrs Noyes
b. 1825
11
Edward Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.2.1.1]
b. 1848
10
Prudence Davis Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.2.2]
b. 20 Nov 1826 d. 17 Oct 1902
Paul Rollins Pickering
b. 8 Nov 1828 d. 18 Jun 1912
11
Walter Rollins Pickering
[1.2.3.10.3.1.1.4.2.2.1]
b. 10 Jan 1857
11
Susan Gertrude Pickering
[1.2.3.10.3.1.1.4.2.2.2]
b. 4 Mar 1859 d. 23 Dec 1925
Gerry Elbridge Towle
b. 11 Sep 1862 d. 7 Nov 1925
12
Walter Eugene Towle
[1.2.3.10.3.1.1.4.2.2.2.1]
b. 10 Dec 1888
12
Ida May Towle
[1.2.3.10.3.1.1.4.2.2.2.2]
b. 1 Jul 1894
11
Alice Louise Pickering
[1.2.3.10.3.1.1.4.2.2.3]
b. 27 Oct 1860
Edward Dunn
12
Ethel Gertrude Dunn
[1.2.3.10.3.1.1.4.2.2.3.1]
b. 23 Feb 1885
12
Edward Arthur Dunn
[1.2.3.10.3.1.1.4.2.2.3.2]
b. 8 Mar 1887
12
Willard Dunn
[1.2.3.10.3.1.1.4.2.2.3.3]
b. 8 Jun 1897
10
Philip Henry Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.2.3]
b. 9 Aug 1828
Lydia H Thompson
b. 1830
11
Florence A Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.2.3.1]
b. 10 Oct 1858
11
Edwin H Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.2.3.2]
b. 1860
9
Abigail Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.3]
b. 15 Jan 1782 d. 30 Sep 1868
Benjamin Currier
d. 9 Dec 1864
10
Lydia Atkinson Currier
[1.2.3.10.3.1.1.4.3.1]
b. 18 Jun 1807
10
Benjamin Currier
[1.2.3.10.3.1.1.4.3.2]
b. 2 Jul 1821 d. 30 Jun 1865
+
Betsey D Foster
b. Abt 1823
9
Peter Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.4]
b. 29 May 1784 d. 26 Dec 1828
Eunice Meserve
b. Abt 1794
10
Abigail Eames Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.4.1]
b. 25 Mar 1816
10
Eliphalet Swett Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.4.2]
b. 30 Jun 1818
Laura K Hill
b. 27 Jul 1824 d. 1886
11
George H Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.4.2.1]
b. 13 Aug 1844
11
Elipha S Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.4.2.2]
b. 7 Oct 1847
11
Edwin B Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.4.2.3]
b. Aug 1849
11
Laura J Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.4.2.4]
b. Abt 1851
11
Frank L Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.4.2.5]
b. Abt 1853
11
Ernest C Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.4.2.6]
b. Abt 1855
10
Martha Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.4.3]
b. 15 Sep 1820 d. 21 Feb 1821
10
Peter W Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.4.4]
b. 18 Apr 1822
10
Martha Jane Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.4.5]
b. 3 Mar 1824
10
Thomas Jefferson Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.4.6]
b. 9 May 1827
9
Rebecca Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.5]
b. 10 Mar 1786 d. 30 Sep 1868
+
Samuel Bickford
b. 13 May 1779 d. 8 May 1863
9
Joseph Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.6]
b. 24 Mar 1788 d. 14 Jan 1850
Mehitabel Chase
b. 1792
10
George Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.6.1]
b. 30 Dec 1813
Mary E Sawyer
b. Abt 1820
11
Mary Francena Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.6.1.1]
b. 5 Jul 1844 d. 1919
Charles Fitch Batchelder
b. 26 May 1843 d. 6 Jan 1887
12
George Noyes Batchelder
[1.2.3.10.3.1.1.4.6.1.1.1]
b. 6 Nov 1866 d. 6 Jan 1887
11
George D Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.6.1.2]
b. 16 Aug 1847
11
William H Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.6.1.3]
b. 29 Apr 1854
10
Rebecca Chase Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.6.2]
b. 12 Mar 1816 d. 18 Dec 1905
Reuel L Cram
b. 8 May 1813 d. 8 Nov 1894
11
Alonzo Cram
[1.2.3.10.3.1.1.4.6.2.1]
b. 24 Dec 1836 d. 4 Feb 1837
11
Ellen Jane Cram
[1.2.3.10.3.1.1.4.6.2.2]
b. 8 Nov 1837
George Henry Moore
b. 1832 d. 1881
12
Charles Carter Moore
[1.2.3.10.3.1.1.4.6.2.2.1]
b. 18 Sep 1854
12
Henry M Moore
[1.2.3.10.3.1.1.4.6.2.2.2]
b. 1860 d. 31 Jul 1861
12
George H Moore
[1.2.3.10.3.1.1.4.6.2.2.3]
b. 1862 d. 17 Jan 1863
12
Nellie Ida Moore
[1.2.3.10.3.1.1.4.6.2.2.4]
b. 4 Jul 1883
11
Charles Noyes Cram
[1.2.3.10.3.1.1.4.6.2.3]
b. 15 Dec 1845 d. 9 Sep 1847
10
Charles Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.6.3]
b. 5 Dec 1817
Hannah Chase
b. 1820
11
Charles M Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.6.3.1]
b. 15 May 1850
11
James H Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.6.3.2]
b. 5 Aug 1855
Sarah E Lunt
b. 14 Dec 1855
12
Marian A Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.6.3.2.1]
b. 13 Nov 1889 d. 1 Mar 1902
12
Pauline Elizabeth Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.6.3.2.2]
b. 19 Oct 1893
10
Daniel Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.6.4]
b. 24 Nov 1821
10
Joseph Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.6.5]
b. 10 Feb 1824
Sarah Leavitt
b. 1825
11
Joseph I Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.6.5.1]
b. 1850
10
Jacob Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.6.6]
b. 15 Oct 1825 d. 21 Mar 1897
Mary Dow
b. 14 Aug 1828
11
Mittie Chase Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.6.6.1]
b. 22 Sep 1853
10
Mary Elizabeth Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.6.7]
b. 4 Nov 1827 d. 27 Nov 1847
10
Henry Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.6.8]
b. 22 Jun 1833 d. 19 Jul 1854
10
Abigail A Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.6.9]
b. 25 Aug 1837
Thomas W Sanborn
b. Jan 1835
11
Josiah Butler Sanborn
[1.2.3.10.3.1.1.4.6.9.1]
b. 1860 d. 1861
11
Thomas Edwin Sanborn
[1.2.3.10.3.1.1.4.6.9.2]
b. Oct 1862
9
Jacob Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.7]
b. 1 Nov 1789 d. 21 Nov 1881
Ann Maria Ede
b. 17 Feb 1825 d. 20 Feb 1913
10
Eliza Ann Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.7.1]
b. 6 Nov 1842
George Green
b. 7 Jan 1835
11
Elma C Green
[1.2.3.10.3.1.1.4.7.1.1]
b. Abt 1866
11
Clara B Green
[1.2.3.10.3.1.1.4.7.1.2]
b. Abt 1869
11
Clayton Lafayette Green
[1.2.3.10.3.1.1.4.7.1.3]
b. 13 Jun 1872
+
Mertie May Kipp
b. 10 Oct 1883 d. 1964
10
George Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.7.2]
b. 15 Dec 1844 d. 12 Dec 1920
Helen Elizabeth Bunker
b. 26 Sep 1852 d. 30 Apr 1925
11
George Myron Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.7.2.1]
b. 26 Aug 1884 d. 23 Nov 1918
Laura Smith
b. 28 Feb 1888 d. Sep 1971
12
Clements Leroy Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.7.2.1.1]
b. 13 Apr 1908 d. 13 May 1962
11
Clyde Wilbur Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.7.2.2]
b. 23 May 1886 d. 9 Feb 1965
11
Myrtle Maria Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.7.2.3]
b. 1 Jul 1888 d. 2 Dec 1958
+
Thomas Rawson Birk
b. 27 Nov 1882
11
Iva Cecelia Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.7.2.4]
b. 31 Mar 1890 d. 6 Jun 1956
Jean Vaughn Steele
b. 8 Jul 1891 d. 29 May 1976
12
Gene Lincoln Steele
[1.2.3.10.3.1.1.4.7.2.4.1]
b. 22 Aug 1912 d. 24 Mar 1992 [
=>
]
12
Cecelia Eola Steele
[1.2.3.10.3.1.1.4.7.2.4.2]
b. 16 May 1914 d. 24 Jun 1968 [
=>
]
12
Virginia Gertrude Steele
[1.2.3.10.3.1.1.4.7.2.4.3]
b. 19 Apr 1916 d. 5 Jul 1988
12
Harvey Wayne Steele
[1.2.3.10.3.1.1.4.7.2.4.4]
b. 19 Feb 1918 d. 13 Nov 1987 [
=>
]
12
Evelyn Viola Steele
[1.2.3.10.3.1.1.4.7.2.4.5]
b. 12 Oct 1919 d. 17 Apr 2008 [
=>
]
12
Shirley Mildred Steele
[1.2.3.10.3.1.1.4.7.2.4.6]
b. 22 Jun 1925 d. 12 Jan 2012
+
Artemus Alonzo "Art" Smith
b. 4 Feb 1878 d. 6 Jun 1967
11
Inez Helen Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.7.2.5]
b. 21 Aug 1891 d. Jul 1983
+
Hans Groth Hansen
b. 27 Aug 1886 d. 19 Dec 1949
11
Raymond Jacob Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.7.2.6]
b. 6 Feb 1893 d. 9 Mar 1935
+
Mary Grindall
b. Abt 1894 d. 1955
10
Abigail Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.7.3]
b. 1847
10
Sophia Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.7.4]
b. 1851 d. 1 Jan 1934
10
Emma Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.7.5]
b. 1853
9
Sally Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.8]
b. 2 Nov 1791 d. 23 Aug 1860
Jonas Wyman
b. 15 Jan 1791 d. 22 Jun 1853
10
Eliza Wyman
[1.2.3.10.3.1.1.4.8.1]
b. 15 Feb 1818 d. 18 May 1908
Moses Fife
b. 8 Feb 1818 d. 25 Aug 1890
11
Micajah N Fife
[1.2.3.10.3.1.1.4.8.1.1]
b. 16 Oct 1840 d. 20 Jul 1925
+
Mary F Ames
11
Mary Frances Fife
[1.2.3.10.3.1.1.4.8.1.2]
b. 1844 d. 1931
11
Seth Wyman Fife
[1.2.3.10.3.1.1.4.8.1.3]
b. 10 Dec 1846 d. 15 Jan 1915
11
Sarah Noyes Fife
[1.2.3.10.3.1.1.4.8.1.4]
b. 17 Nov 1854 d. 28 Mar 1922
10
Abigail Wyman
[1.2.3.10.3.1.1.4.8.2]
b. 26 Jul 1821 d. 9 Nov 1909
Daniel Chandler
b. 22 Sep 1821 d. 29 Dec 1894
11
David Hardy Chandler
[1.2.3.10.3.1.1.4.8.2.1]
b. 29 Feb 1848 d. 14 Oct 1906
+
Edna Wiley
b. 16 Feb 1861
11
Celissa Chandler
[1.2.3.10.3.1.1.4.8.2.2]
b. 7 Oct 1851 d. 26 Sep 1853
11
Hazen Chandler
[1.2.3.10.3.1.1.4.8.2.3]
b. 5 Feb 1855 d. 2 Aug 1923
+
Rose Wiley
b. 1864
11
Marshall Chandler
[1.2.3.10.3.1.1.4.8.2.4]
b. 21 May 1858 d. 14 Mar 1862
11
Nellie Chandler
[1.2.3.10.3.1.1.4.8.2.5]
b. 26 May 1864 d. 1925
Isaac S McAllister
b. 9 Sep 1858 d. 9 Apr 1909
12
Marshall Chandler McCallister
[1.2.3.10.3.1.1.4.8.2.5.1]
b. 13 Dec 1884 [
=>
]
10
Seth Wyman
[1.2.3.10.3.1.1.4.8.3]
b. 31 Aug 1823 d. 22 Sep 1883
Susan Hardwick Chandler
b. 26 Jan 1831 d. 10 Sep 1862
11
Joseph Leavitt Wyman
[1.2.3.10.3.1.1.4.8.3.1]
b. 10 Oct 1850 d. 3 Nov 1877
+
Hannah L Emerson
b. 1852
11
Nancy Greely Wyman
[1.2.3.10.3.1.1.4.8.3.2]
b. 16 Jun 1852 d. 24 Jul 1891
Dexter Charles
b. 21 Aug 1848 d. 15 Mar 1934
12
Mark N Charles
[1.2.3.10.3.1.1.4.8.3.2.1]
b. 28 Mar 1873 [
=>
]
12
Leon Dexter Charles
[1.2.3.10.3.1.1.4.8.3.2.2]
b. 28 Jun 1876
12
Fannie W Charles
[1.2.3.10.3.1.1.4.8.3.2.3]
b. 1879
11
Nellie F Wyman
[1.2.3.10.3.1.1.4.8.3.3]
b. 17 Mar 1856
Fred C Stevens
b. Abt 1855
12
Gertrude Clare Stevens
[1.2.3.10.3.1.1.4.8.3.3.1]
b. 2 Jun 1876
11
Fannie Noyes Wyman
[1.2.3.10.3.1.1.4.8.3.4]
b. 24 Sep 1859 d. 22 Mar 1939
John W Smart
b. 15 Apr 1858
12
Wyman Smart
[1.2.3.10.3.1.1.4.8.3.4.1]
b. 9 Dec 1891
11
Susan Chandler Wyman
[1.2.3.10.3.1.1.4.8.3.5]
b. 27 Jul 1862 d. 10 Mar 1943
Fred Wallace Powers
b. 31 May 1855 d. 27 Nov 1952
12
Wallace Merton Powers
[1.2.3.10.3.1.1.4.8.3.5.1]
b. 18 Jul 1882 d. 10 Apr 1968
12
Harold Wyman Powers
[1.2.3.10.3.1.1.4.8.3.5.2]
b. 20 Mar 1884 d. 8 Oct 1943
12
Doris Hazel Powers
[1.2.3.10.3.1.1.4.8.3.5.3]
b. 23 Jun 1890 d. 11 Oct 1963 [
=>
]
12
Frederick Webster Powers
[1.2.3.10.3.1.1.4.8.3.5.4]
b. 14 May 1894 d. Nov 1943 [
=>
]
+
Clara H Rollins
b. 1845 d. Aft 1884
10
Jonas Wyman
[1.2.3.10.3.1.1.4.8.4]
b. 8 Nov 1827 d. 24 Oct 1863
10
Susan Wyman
[1.2.3.10.3.1.1.4.8.5]
b. 1830
9
Fanny Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.9]
b. 14 Feb 1794 d. 3 May 1856
9
Nancy Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.10]
b. 6 Jul 1796 d. 15 Mar 1826
Paine Davis Badger
b. 31 Jul 1796 d. 9 May 1863
10
Eliphlet Noyes Badger
[1.2.3.10.3.1.1.4.10.1]
b. 9 May 1820 d. 18 Feb 1889
Sarah Frances Pettingill
b. 11 Dec 1822 d. 16 Jan 1895
11
Sarah Frances Badger
[1.2.3.10.3.1.1.4.10.1.1]
b. 17 Sep 1843
Edward Payson Tenney
b. 16 Sep 1844
12
Edward F Tenney
[1.2.3.10.3.1.1.4.10.1.1.1]
b. 28 Feb 1868 d. Bef 1880
12
Carrie Appleton Tenney
[1.2.3.10.3.1.1.4.10.1.1.2]
b. 26 Aug 1870
12
Marion L Tenney
[1.2.3.10.3.1.1.4.10.1.1.3]
b. 5 Apr 1874
11
John Pettingell Badger
[1.2.3.10.3.1.1.4.10.1.2]
b. 6 Nov 1845 d. 30 Dec 1889
Frances Proeschold
b. 6 Dec 1849 d. 30 Jul 1892
12
John Loomis Badger
[1.2.3.10.3.1.1.4.10.1.2.1]
b. 14 Mar 1874 d. 1939 [
=>
]
12
Gertrude F Badger
[1.2.3.10.3.1.1.4.10.1.2.2]
b. 20 Feb 1876
11
George Henry Badger
[1.2.3.10.3.1.1.4.10.1.3]
b. 24 Jan 1848 d. 7 Nov 1870
+
Sarah Greenough Dillaway
b. 19 Sep 1849 d. 5 Sep 1888
11
Arthur E Badger
[1.2.3.10.3.1.1.4.10.1.4]
b. 16 Apr 1850 d. 6 Apr 1891
11
Mary Eliza Badger
[1.2.3.10.3.1.1.4.10.1.5]
b. 26 Mar 1853 d. 16 Nov 1873
+
George H Bates
b. 2 Nov 1851
11
Edward Noyes Badger
[1.2.3.10.3.1.1.4.10.1.6]
b. 28 Apr 1858 d. 19 Oct 1906
Maria Louise Rider
b. Oct 1856
12
Louise G Badger
[1.2.3.10.3.1.1.4.10.1.6.1]
b. 4 Jun 1889
10
George W Badger
[1.2.3.10.3.1.1.4.10.2]
b. 1822 d. 20 Jun 1856
Mary Ann Tripp
11
Georgianna Badger
[1.2.3.10.3.1.1.4.10.2.1]
b. 8 May 1845
11
Sarah Frances Badger
[1.2.3.10.3.1.1.4.10.2.2]
b. 30 Sep 1848
10
Elizabeth Badger
[1.2.3.10.3.1.1.4.10.3]
b. 1824 d. 1874
9
Micajah Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.11]
b. 7 Aug 1798
Elizabeth Chamberlain
b. Abt 1801
10
Micajah Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.11.1]
b. Oct 1831 d. 4 Feb 1895
Mrs. Noyes
b. 1835
11
Harry B Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.11.1.1]
b. 28 Dec 1864
11
William A Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.11.1.2]
b. 18 Oct 1872
10
Lizzie N Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.11.2]
b. Abt 1833
10
Jennie Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.11.3]
b. Abt 1835
10
Son Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.11.4]
b. 1837
9
Eliphalet Swett Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.4.12]
b. 7 Mar 1802 d. 17 Apr 1820
8
Enoch Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5]
b. 28 Mar 1750 d. 20 May 1842
Eunice Kinsman
b. Abt 1749
9
Betsy Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.1]
b. 13 Dec 1771 d. 1848
+
Jesse Frye
9
Elizabeth Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.2]
b. 13 Dec 1771
9
Eunice Kinsman Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.3]
b. 21 Apr 1774 d. 5 Aug 1853
Amos Bartlett
b. Abt 1770 d. 20 Aug 1828
10
Stephen Noyes Bartlett
[1.2.3.10.3.1.1.5.3.1]
b. 1 Dec 1802 d. 15 Nov 1879
Theodisa Child
b. 18 Sep 1802 d. 31 Jan 1882
11
Emery Sargent Bartlett
[1.2.3.10.3.1.1.5.3.1.1]
b. 18 Sep 1828 d. 27 Oct 1864
Hannah Stephens
b. 5 Feb 1836 d. 4 May 1907
12
Arthur Willard Bartlett
[1.2.3.10.3.1.1.5.3.1.1.1]
b. 20 May 1862 d. 11 May 1928 [
=>
]
12
Stella Theodotia Bartlett
[1.2.3.10.3.1.1.5.3.1.1.2]
b. 18 Apr 1869
12
Katherine Hannah Bartlett
[1.2.3.10.3.1.1.5.3.1.1.3]
b. 11 Jan 1872
11
Eliza Ann Bartlett
[1.2.3.10.3.1.1.5.3.1.2]
b. 18 Sep 1828 d. 27 Oct 1864
+
Benoni Howard
b. 2 Aug 1820
11
Moses Willard Bartlett
[1.2.3.10.3.1.1.5.3.1.3]
b. 26 Feb 1834 d. 30 Nov 1912
Julia Abbot
b. 7 Oct 1835 d. 25 Dec 1904
12
Herbert Willard Bartlett
[1.2.3.10.3.1.1.5.3.1.3.1]
b. 1 May 1860 d. 22 Jul 1860
12
William Abbott Bartlett
[1.2.3.10.3.1.1.5.3.1.3.2]
b. 27 Sep 1861 d. 28 Jan 1943 [
=>
]
12
Mary Ellen Bartlett
[1.2.3.10.3.1.1.5.3.1.3.3]
b. 5 Sep 1872
11
Stanley Moulton Bartlett
[1.2.3.10.3.1.1.5.3.1.4]
b. 4 Dec 1836 d. 24 Nov 1908
+
Sarah Jane Grinnell
11
Philomela Minerva Bartlett
[1.2.3.10.3.1.1.5.3.1.5]
b. 23 Jul 1839 d. 25 Aug 1903
+
John P Parke
b. 13 Nov 1836 d. 24 Mar 1888
10
Sukey Bartlett
[1.2.3.10.3.1.1.5.3.2]
b. 28 Apr 1800
10
Joseph K Bartlett
[1.2.3.10.3.1.1.5.3.3]
b. 7 May 1805 d. 1832
10
Philomela Bartlett
[1.2.3.10.3.1.1.5.3.4]
b. 22 May 1808
+
John Gardner
10
Julia Ann Bartlett
[1.2.3.10.3.1.1.5.3.5]
b. 10 Nov 1810 d. 7 Apr 1894
10
Enoch Noyes Bartlett
[1.2.3.10.3.1.1.5.3.6]
b. 4 Jul 1813 d. 14 Aug 1897
Emily Smith
b. 27 May 1814
11
Julia E Bartlett
[1.2.3.10.3.1.1.5.3.6.1]
b. 1843 d. 1844
11
George W Bartlett
[1.2.3.10.3.1.1.5.3.6.2]
b. 3 Sep 1845
11
Joseph E Bartlett
[1.2.3.10.3.1.1.5.3.6.3]
b. 5 Oct 1848
11
Horace M Bartlett
[1.2.3.10.3.1.1.5.3.6.4]
b. 7 Apr 1859
10
Moses Emery Bartlett
[1.2.3.10.3.1.1.5.3.7]
b. 30 Apr 1816 d. 21 Feb 1847
Catharine C Kirby
b. 8 Dec 1816 d. 6 Aug 1842
11
Henry Lindsley Barlett
[1.2.3.10.3.1.1.5.3.7.1]
b. 20 Sep 1838 d. 14 Oct 1838
11
Maria Jackson Barlett
[1.2.3.10.3.1.1.5.3.7.2]
b. 16 Jan 1841 d. 15 Oct 1903
John Newell Hibbard
b. 9 Nov 1833 d. 30 Aug 1878
12
Catherine Maria Hibbard
[1.2.3.10.3.1.1.5.3.7.2.1]
b. 9 Nov 1864
11
Julia Ann Barlett
[1.2.3.10.3.1.1.5.3.7.3]
b. 15 Jul 1842 d. 17 Sep 1896
9
Isaac Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.4]
b. 3 Jan 1776 d. 3 Dec 1862
Rachel Worthley
b. Abt 1782 d. 25 Apr 1841
10
Bradley Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.1]
b. 20 Feb 1801 d. 14 May 1858
Martha Sullivan Bordwell
b. 21 Nov 1809 d. 1868
11
Isabella Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.1.1]
b. 30 Sep 1830 d. 22 Jul 1901
11
Sophia M Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.1.2]
b. 20 Sep 1832
Henry Warren Warner
b. 19 Aug 1823 d. 22 May 1895
12
Isabella Nettie Warner
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.1.2.1]
b. 7 Nov 1865
12
Edward Russell Warner
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.1.2.2]
b. 15 Nov 1869
12
Mabel Remington Warner
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.1.2.3]
b. 24 Aug 1871
11
Thomas Jefferson Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.1.3]
b. 2 Dec 1834
Sarah Maria Browning
b. 20 Jul 1834
12
Edward Browning Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.1.3.1]
b. 29 Oct 1871 d. 1956
12
Elizabeth B Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.1.3.2]
b. 18 Jun 1868 d. 16 Mar 1950
12
Martha Bardwell Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.1.3.3]
b. 1870 d. 1872
12
Irene B Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.1.3.4]
b. Abt 1873 d. 1969
12
Baxter Bardwell Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.1.3.5]
b. 24 Apr 1876 d. 2 Sep 1960 [
=>
]
11
Edward Livingston Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.1.4]
b. 21 Sep 1836 d. 30 Oct 1933
Louise Town
b. 1840
12
Luella Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.1.4.1]
b. 1857
12
Edward Livingston Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.1.4.2]
b. 28 Sep 1859 d. 29 Jun 1945
12
Sarah Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.1.4.3]
b. 1861
11
Martha Ann Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.1.5]
b. 30 Aug 1838
11
Luella S Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.1.6]
b. 15 May 1841 d. 1876
11
Baxter Buffman Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.1.7]
b. 22 Aug 1843 d. 22 Jul 1912
Margaret Sophia Totman
b. 25 Jan 1851 d. 6 Jan 1926
12
Baxter Buffman Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.1.7.1]
b. 18 Oct 1872 d. 4 Feb 1908
12
Theodore Livingston Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.1.7.2]
b. 18 May 1875 d. 1876
12
Gertrude Sophia Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.1.7.3]
b. 5 Dec 1876
12
Martha B Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.1.7.4]
b. 5 Dec 1878
12
Winthrop T Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.1.7.5]
b. 2 Jun 1883
12
Mabel Ella Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.1.7.6]
b. 7 Feb 1885 d. 1904
11
Joseph B Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.1.8]
b. 9 Apr 1854
10
Ann Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.2]
b. 25 May 1806 d. 1 Sep 1849
David Rollins
b. 9 Jan 1790 d. 18 Mar 1874
11
Judith Louisa Rollins
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.2.1]
b. 5 Jul 1815 d. 30 Apr 1890
Maturin Ballou Hall
b. 22 Mar 1809 d. 5 Feb 1901
12
Merrill Rollins Hall
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.2.1.1]
b. 29 Mar 1849 d. 29 May 1928 [
=>
]
12
Son Hall
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.2.1.2]
b. 12 Jul 1834 d. 1834
12
Emilie Mandane Hall
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.2.1.3]
b. 5 Nov 1837 d. 21 Oct 1885 [
=>
]
12
Ellen Mindwell Hall
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.2.1.4]
b. 7 Nov 1840 d. 23 Jan 1843
12
Rufus David Hall
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.2.1.5]
b. 12 Oct 1842 d. 10 Sep 1843
12
Jane M Hall
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.2.1.6]
b. 20 Jun 1844 d. 13 Mar 1925 [
=>
]
12
Azro Drown Hall
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.2.1.7]
b. 27 Sep 1847 d. 27 Jan 1907 [
=>
]
12
Phebe A Hall
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.2.1.8]
b. 1850 d. 9 May 1853
12
Henrietta Ballou Hall
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.2.1.9]
b. 10 Aug 1858 d. 6 Feb 1914 [
=>
]
11
Asenath Rawlins
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.2.2]
b. 16 Sep 1817
11
Emily Rawlins
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.2.3]
b. 5 Dec 1819
Henry H Elkins
b. 1815 d. 3 Nov 1885
12
David Elkins
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.2.3.1]
b. 1838
12
Emily Elkins
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.2.3.2]
b. 1840
12
Hattie Elkins
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.2.3.3]
b. 1844
12
Harrison Elkins
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.2.3.4]
b. 1846
11
Eliza A Rollins
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.2.4]
b. 13 Feb 1822
William J Stanton
b. 25 Dec 1813 d. 16 May 1862
12
William David Stanton
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.2.4.1]
b. 10 Oct 1843 d. 19 Sep 1875 [
=>
]
12
Stiles Johnson Stanton
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.2.4.2]
b. 29 Mar 1846 d. 22 Oct 1890
11
Joseph L Rollins
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.2.5]
b. 23 Feb 1825
11
Mary J Rawlins
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.2.6]
b. 17 Jan 1828
11
Harriet Rawlins
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.2.7]
b. 28 Apr 1830
11
David H Rollins
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.2.8]
b. 22 Aug 1840
10
Mary Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.3]
b. 23 Oct 1808
10
Isaac Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.4]
b. 6 Jan 1811 d. 31 Dec 1876
Eliza Stephens
b. Abt 1811
11
Emily Kinsman Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.4.1]
b. 17 Feb 1834 d. 18 Aug 1916
Robert E Jones
b. Dec 1832 d. 13 Mar 1903
12
John Jones
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.4.1.1]
b. 1854
12
Albert D Jones
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.4.1.2]
b. 1858
12
Herbert I Jones
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.4.1.3]
b. Feb 1860
12
Evan E Jones
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.4.1.4]
b. 1863
12
Evy E Jones
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.4.1.5]
b. 1863
12
Harry Eugene Jones
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.4.1.6]
b. 23 Nov 1865 d. 14 Mar 1945
12
Gracy Jones
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.4.1.7]
b. 1870
11
Ursula A Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.4.2]
b. 13 Mar 1840
+
Edward S Mimiman
11
Joseph S Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.4.3]
b. 1 Jul 1842 d. 28 May 1881
11
Samuel W D Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.4.4]
b. 7 Feb 1846
Dilla Shepard
b. 1848
12
Guy E Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.4.4.1]
b. 1871
12
Carl C Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.4.4.2]
b. 1873
12
Ray Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.4.4.3]
b. 1875
11
Harriet C Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.4.5]
b. 2 Aug 1848
+
Bert E Clark
11
Isaac E Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.4.6]
b. 24 Sep 1852 d. 19 Feb 1864
11
Dewitt C Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.4.7]
b. 12 Nov 1854
11
Son Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.4.8]
b. 1856
11
Son Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.4.9]
b. 1858
10
Enoch Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.5]
b. 12 Mar 1814 d. 9 Jul 1852
Margaret Oliver
b. 1818 d. 4 Oct 1885
11
Enoch Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.5.1]
b. 27 Dec 1837 d. 27 Dec 1837
11
Mary Frances Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.5.2]
b. 1842
11
Isaac Enoch Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.5.3]
b. 1844
10
Samuel Newell Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.6]
b. 19 Jul 1818
Mary A Curtis
b. Abt 1826
11
Algernon F Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.6.1]
b. 12 Nov 1848 d. 9 Nov 1891
Amy Baker
b. 1852
12
Bessie Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.6.1.1]
b. 28 Nov 1883
12
Fred A Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.6.1.2]
b. 11 Jan 1885 d. 18 Sep 1886
12
William B Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.6.1.3]
b. 22 Sep 1891
11
Eda Mara Augusta Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.6.2]
b. 21 May 1850 d. 8 Sep 1918
Erwin Luther Atwood
b. 10 Aug 1850
12
Roy Almon Atwood
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.6.2.1]
b. 10 Sep 1875 d. 11 May 1952
12
Archie Erwin Atwood
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.6.2.2]
b. 3 Feb 1877 d. 4 Mar 1878
12
Lynn Leigh Atwood
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.6.2.3]
b. 22 Aug 1878 d. 19 Dec 1909
12
Earl Noyles Atwood
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.6.2.4]
b. 5 Apr 1882 d. 2 Dec 1932
12
Fern Quintus Atwood
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.6.2.5]
b. 20 Jan 1884 d. 15 Aug 1937
12
Edwin Dee Atwood
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.6.2.6]
b. 17 Dec 1885 d. 26 Apr 1936
12
Gene Curtis Atwood
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.6.2.7]
b. 4 Apr 1889 d. 1 Aug 1957 [
=>
]
12
Hazel Marie Atwood
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.6.2.8]
b. 9 Jan 1891 d. 16 Jul 1975
12
Ivy Royal Atwood
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.6.2.9]
b. 13 May 1892 d. 12 Jan 1971
11
Gerza H Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.6.3]
b. 16 Feb 1852 d. 1899
+
Fannie Sunderland
10
Ursula Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.7]
b. 30 Aug 1821 d. 23 Dec 1866
Lorenzo Dow Livermore
b. 28 Nov 1819 d. 14 May 1906
11
Orell Bradley Livermore
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.7.1]
b. 9 Jun 1845 d. 29 Aug 1848
11
Aldrick Clarence Livermore
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.7.2]
b. 29 Oct 1848 d. 29 Jul 1862
11
Elgin Serino Livermore
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.7.3]
b. 17 May 1850
11
Adelphia Ursula Livermore
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.7.4]
b. 23 Oct 1853
+
George Abram Hawes
b. 19 Dec 1852
11
Winslow Odell Livermore
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.7.5]
b. 17 May 1856 d. Aft 1902
Jennet Ransom Raymond
b. 7 Feb 1858
12
Florence Dana Livermore
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.7.5.1]
b. 22 Sep 1881
12
George Raimond Livermore
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.7.5.2]
b. 10 Feb 1885
12
Joseph Dow Livermore
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.7.5.3]
b. 8 Jul 1888
11
Benjamin Franklin Livermore
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.7.6]
b. 30 Jan 1860 d. Aft 1902
Minnie Genevie Fraiser
b. 9 Mar 1863
12
Elgin Livermore
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.7.6.1]
b. 25 Jun 1884
12
Eugene Alfred Livermore
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.7.6.2]
b. 19 Apr 1885
12
Roy Benjamin Livermore
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.7.6.3]
b. 29 Oct 1886
12
Glen Forest Livermore
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.7.6.4]
b. 14 Apr 1888
12
Lura Livermore
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.7.6.5]
b. 11 Nov 1889
11
Alfrenzo Livermore
[1.2.3.10.3.1.1.5.4.7.7]
b. 10 Jun 1864 d. 24 Jun 1864
9
Enoch Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.5]
b. 15 Dec 1777 d. 1800
+
Abigail
b. 1779
9
Lydia Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.6]
b. 26 Nov 1779 d. 8 Aug 1818
Aaron Manning
b. 1 Apr 1775 d. 15 Jun 1827
10
James Manning
[1.2.3.10.3.1.1.5.6.1]
b. 28 Nov 1800 d. 11 Jul 1811
10
Enoch Noyes Manning
[1.2.3.10.3.1.1.5.6.2]
b. 13 Jul 1802 d. 1858
10
Stephen Noyes Manning
[1.2.3.10.3.1.1.5.6.3]
b. 24 Oct 1804
+
Lucy Prescott
b. 10 Jul 1810 d. 21 Apr 1867
10
Aaron Manning
[1.2.3.10.3.1.1.5.6.4]
b. 17 Aug 1806 d. 18 Mar 1845
+
Harriet Elizabeth McCarty
b. 16 Feb 1812 d. 19 Oct 1883
10
Jesse King Manning
[1.2.3.10.3.1.1.5.6.5]
b. 1 Feb 1809
+
Jane Ann Marshall
b. 15 Dec 1815 d. 10 Mar 1853
10
Son Manning
[1.2.3.10.3.1.1.5.6.6]
b. 1811 d. 1811
10
James Maddison Manning
[1.2.3.10.3.1.1.5.6.7]
b. 4 Mar 1812 d. 1872
+
Mary Ann Wool
10
Eunice Kinsman Manning
[1.2.3.10.3.1.1.5.6.8]
b. 9 Jan 1814 d. 5 Aug 1892
Leander Danforth
b. 30 Jan 1807 d. 8 Jul 1882
11
Eudora Elizabeth Danforth
[1.2.3.10.3.1.1.5.6.8.1]
b. 26 Jun 1841
11
Florence Arrabel Danforth
[1.2.3.10.3.1.1.5.6.8.2]
b. 10 Nov 1843
George Stamp
b. 15 Apr 1828 d. 29 May 1871
12
Clarence George Stamp
[1.2.3.10.3.1.1.5.6.8.2.1]
b. 22 Jan 1869 d. 24 Dec 1925 [
=>
]
11
Rosalie Aurelia Danforth
[1.2.3.10.3.1.1.5.6.8.3]
b. 6 Oct 1847 d. 23 Oct 1880
10
Lydia Noyes Manning
[1.2.3.10.3.1.1.5.6.9]
b. 12 May 1816 d. 8 Sep 1837
10
William Manning
[1.2.3.10.3.1.1.5.6.10]
b. 12 Jun 1818 d. 23 Oct 1891
Agnes Magdelen Witbeck
b. 19 Mar 1821 d. 6 Jun 1896
11
Daniel Francis Manning
[1.2.3.10.3.1.1.5.6.10.1]
b. 9 Sep 1839
11
Egbert Addison Manning
[1.2.3.10.3.1.1.5.6.10.2]
b. 3 Mar 1843 d. 1900
Sarah Augusta Spencer
b. Jul 1843 d. 1910
12
Elmer Addison Manning
[1.2.3.10.3.1.1.5.6.10.2.1]
b. 22 Oct 1863 d. Sep 1867
12
Eva Augusta Manning
[1.2.3.10.3.1.1.5.6.10.2.2]
b. 2 May 1867 d. 1868
12
Arthur Manning
[1.2.3.10.3.1.1.5.6.10.2.3]
b. 1870 d. 1870
11
James Frederick Manning
[1.2.3.10.3.1.1.5.6.10.3]
b. 5 Apr 1847
+
Alice Jane Ostrander
11
Agnes Lydia Manning
[1.2.3.10.3.1.1.5.6.10.4]
b. 11 Sep 1849 d. 5 Apr 1927
Joseph Stephen Dwinelle
b. 23 Mar 1850 d. 5 May 1926
12
Percy Manning Dwinelle
[1.2.3.10.3.1.1.5.6.10.4.1]
b. 28 Sep 1875 d. 4 Aug 1968
12
Walter James Dwinelle
[1.2.3.10.3.1.1.5.6.10.4.2]
b. 20 Feb 1877 d. 29 Jan 1974
12
Helena May Dwinelle
[1.2.3.10.3.1.1.5.6.10.4.3]
b. 5 May 1879 d. 11 Aug 1888
12
Louise Edgar Dwinelle
[1.2.3.10.3.1.1.5.6.10.4.4]
b. 14 Sep 1881
12
William Colett Dwinelle
[1.2.3.10.3.1.1.5.6.10.4.5]
b. 15 Jul 1885 d. 15 Mar 1935
12
Fred Royal Dwinelle
[1.2.3.10.3.1.1.5.6.10.4.6]
b. 27 Dec 1889 d. 8 Feb 1936 [
=>
]
9
Susan Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.7]
b. 3 Dec 1781
Moses Sargent
b. 1782 d. 11 Jun 1820
10
Angeline Sargent
[1.2.3.10.3.1.1.5.7.1]
b. 2 Nov 1805
+
Elijah Hathaway
b. 19 Jan 1794 d. 24 Apr 1880
10
Susan M Sargent
[1.2.3.10.3.1.1.5.7.2]
b. 12 Apr 1811 d. 1888
Calvin Sabin Grow
b. 6 Mar 1805 d. 13 May 1896
11
Lucius A Grow
[1.2.3.10.3.1.1.5.7.2.1]
b. 7 Sep 1832
11
Perlina L Grow
[1.2.3.10.3.1.1.5.7.2.2]
b. 16 Mar 1834 d. 3 Jan 1909
+
Ira H Bickford
b. 29 Feb 1832 bur. 22 Feb 1940
11
Annie E Grow
[1.2.3.10.3.1.1.5.7.2.3]
b. 11 Aug 1836
+
P J Bailey
b. Abt 1834
11
Helen A Grow
[1.2.3.10.3.1.1.5.7.2.4]
b. 14 Aug 1840 d. 14 Nov 1861
11
Florence A Grow
[1.2.3.10.3.1.1.5.7.2.5]
b. 1 May 1844
Calvin W Richardson
b. 30 Jan 1841 d. 19 Oct 1886
12
Fred E Richardson
[1.2.3.10.3.1.1.5.7.2.5.1]
b. 1867
12
Harry L Richardson
[1.2.3.10.3.1.1.5.7.2.5.2]
b. 2 Mar 1868
12
Charlie Richardson
[1.2.3.10.3.1.1.5.7.2.5.3]
b. 28 Oct 1869
12
Ellen Richardson
[1.2.3.10.3.1.1.5.7.2.5.4]
b. 1876
12
Georgie Richardson
[1.2.3.10.3.1.1.5.7.2.5.5]
b. 1879
11
James M Grow
[1.2.3.10.3.1.1.5.7.2.6]
b. 1 May 1844
9
Stephen Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.8]
b. 5 Jul 1783 d. 1866
Sarah Abbott
b. 3 Oct 1788
10
Enoch Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.8.1]
b. 16 Jul 1806 d. 18 May 1811
10
Susan Parker Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.8.2]
b. 12 Nov 1808 d. 31 Jan 1846
Joshua D Allen
b. 1800
11
Stephen N Allen
[1.2.3.10.3.1.1.5.8.2.1]
b. 28 May 1830
11
Joshua B Allen
[1.2.3.10.3.1.1.5.8.2.2]
b. 9 Mar 1832
11
Sarah N Allen
[1.2.3.10.3.1.1.5.8.2.3]
b. 19 Nov 1834
11
Joseph S Allen
[1.2.3.10.3.1.1.5.8.2.4]
b. 15 Jul 1840
10
Benjamin A Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.8.3]
b. 16 Mar 1811 d. 13 Feb 1865
Lucy A Thompson
b. Abt 1813 d. Aft 1839
11
Lucia A Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.8.3.1]
b. 22 Nov 1835
11
Lavina Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.8.3.2]
b. 10 Sep 1839
10
Stephen Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.8.4]
b. 26 May 1817 d. 22 Mar 1822
9
Dorcas Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.9]
b. 22 Mar 1786 d. 27 Feb 1877
Benjamin Abbott
b. 23 Sep 1786 d. 22 Jun 1853
10
Ephraim Abbott
[1.2.3.10.3.1.1.5.9.1]
b. 25 Oct 1808 d. Apr 1813
10
Susannah Manning Abbott
[1.2.3.10.3.1.1.5.9.2]
b. 13 Dec 1810 d. Mar 1898
Jesse Frye
b. 15 Feb 1813 d. 1864
11
Benjamin Abbott Frye
[1.2.3.10.3.1.1.5.9.2.1]
b. 18 Aug 1843
Ellen Wallace
b. 1850
12
Clarra Frye
[1.2.3.10.3.1.1.5.9.2.1.1]
b. 1874
12
Eugene Frye
[1.2.3.10.3.1.1.5.9.2.1.2]
b. 1875
12
Mabel Frye
[1.2.3.10.3.1.1.5.9.2.1.3]
b. 1878
12
Elizabeth Frye
[1.2.3.10.3.1.1.5.9.2.1.4]
b. 1879
11
Eunice Laura Frye
[1.2.3.10.3.1.1.5.9.2.2]
b. 9 Jun 1847
10
Peter Green Abbott
[1.2.3.10.3.1.1.5.9.3]
b. 8 May 1815 d. 7 Nov 1829
10
Enoch Noyes Abbott
[1.2.3.10.3.1.1.5.9.4]
b. 16 Dec 1817 d. 18 Feb 1855
Maria H Wood
b. Abt 1821 d. 6 Jun 1866
11
Mary B Abbott
[1.2.3.10.3.1.1.5.9.4.1]
b. 15 Jun 1846 d. Abt 1870
11
Susan Maria Abbott
[1.2.3.10.3.1.1.5.9.4.2]
b. Abt 1848
10
Asa McFarland Abbott
[1.2.3.10.3.1.1.5.9.5]
b. 16 Nov 1820 d. 8 Apr 1889
Sarah Sperry
b. 18 Feb 1822 d. 12 May 1900
11
Charles Enoch Abbott
[1.2.3.10.3.1.1.5.9.5.1]
b. 22 Dec 1847 d. 10 Jan 1928
Sarah Elizabeth Sperry
b. 16 Aug 1852 d. 22 Jun 1943
12
Charles Asa Abbott
[1.2.3.10.3.1.1.5.9.5.1.1]
b. 12 Apr 1873 d. 23 Dec 1878
12
Sarah Emma Abbott
[1.2.3.10.3.1.1.5.9.5.1.2]
b. 28 Aug 1874 d. 10 Dec 1956 [
=>
]
12
Theresa May Abbott
[1.2.3.10.3.1.1.5.9.5.1.3]
b. 16 Oct 1876 d. 25 Dec 1878
12
Theodore Alfred Abbott
[1.2.3.10.3.1.1.5.9.5.1.4]
b. 16 Oct 1876 d. 31 Dec 1878
12
Ruth Maud Abbott
[1.2.3.10.3.1.1.5.9.5.1.5]
b. 2 Nov 1879 d. 4 Apr 1961
12
Minnie Lamont Abbott
[1.2.3.10.3.1.1.5.9.5.1.6]
b. 2 Nov 1879 d. 29 Oct 1932 [
=>
]
12
Frank William Abbott
[1.2.3.10.3.1.1.5.9.5.1.7]
b. 1 Oct 1881 d. 19 Jun 1883
12
Edward Harrison Abbott
[1.2.3.10.3.1.1.5.9.5.1.8]
b. 27 Mar 1886 d. 1 Jun 1887
12
Earl Leroy Abbott
[1.2.3.10.3.1.1.5.9.5.1.9]
b. 11 Oct 1887
12
Ralph Morton Abbott
[1.2.3.10.3.1.1.5.9.5.1.10]
b. 22 Feb 1892
12
Joseph Leonard Abbott
[1.2.3.10.3.1.1.5.9.5.1.11]
b. 28 Jan 1894
12
Arthur A Abbott
[1.2.3.10.3.1.1.5.9.5.1.12]
b. 7 Jun 1896 d. 17 Nov 1928
11
John Morton Abbott
[1.2.3.10.3.1.1.5.9.5.2]
b. 25 Mar 1850 d. 16 May 1936
Hannah Elizabeth Knight
b. 16 Mar 1853 d. 11 May 1926
12
Ruth Maude Abbott
[1.2.3.10.3.1.1.5.9.5.2.1]
b. Abt 1869 [
=>
]
12
Alfred M Abbott
[1.2.3.10.3.1.1.5.9.5.2.2]
b. Jul 1873
12
Myra Abbott
[1.2.3.10.3.1.1.5.9.5.2.3]
b. 1878
12
Bessie M Abbott
[1.2.3.10.3.1.1.5.9.5.2.4]
b. May 1884
12
Bernard V Abbott
[1.2.3.10.3.1.1.5.9.5.2.5]
b. May 1884
12
Iva P Abbott
[1.2.3.10.3.1.1.5.9.5.2.6]
b. Mar 1886
11
Ruth Abbott
[1.2.3.10.3.1.1.5.9.5.3]
b. 23 Jun 1852 d. 12 May 1855
11
Theodore Sperry Abbott
[1.2.3.10.3.1.1.5.9.5.4]
b. 23 Sep 1855 d. 16 Aug 1934
+
Aurelia Eelle
b. Abt 1859 d. Aug 1902
+
Grace Alling
b. Abt 1859 d. 1935
11
Edward Lorenzo Abbott
[1.2.3.10.3.1.1.5.9.5.5]
b. 15 Feb 1859 d. 30 Sep 1938
+
Lillian Ida Hartwell
b. 13 May 1858 d. 3 May 1942
11
William Lamont Abbott
[1.2.3.10.3.1.1.5.9.5.6]
b. 14 Feb 1861 d. 20 Feb 1951
Caroline Entwhistle
b. 27 Jul 1859 d. 26 Oct 1946
12
Arthur William Abbott
[1.2.3.10.3.1.1.5.9.5.6.1]
b. 21 Mar 1890 d. Sep 1971
12
Helen Abbott
[1.2.3.10.3.1.1.5.9.5.6.2]
b. 5 Jul 1891 d. 3 Nov 1932
12
Robert E Abbott
[1.2.3.10.3.1.1.5.9.5.6.3]
b. 14 Sep 1895 d. Nov 1967
12
Josephine E Abbott
[1.2.3.10.3.1.1.5.9.5.6.4]
b. 19 Nov 1898
12
Dorothy Caroline Abbott
[1.2.3.10.3.1.1.5.9.5.6.5]
b. 5 Sep 1902 d. 14 Jan 1992
11
Alfred Noyes Abbott
[1.2.3.10.3.1.1.5.9.5.7]
b. 2 Nov 1862 d. 14 Sep 1929
Sarah S Green
b. 3 Apr 1865 d. 20 Nov 1956
12
Bayard Taylor Abbott
[1.2.3.10.3.1.1.5.9.5.7.1]
b. 5 Nov 1887 d. 7 Dec 1973
12
Frances Dorcas Abbott
[1.2.3.10.3.1.1.5.9.5.7.2]
b. Jan 1889 d. Aug 1987 [
=>
]
12
Louis A Abbott
[1.2.3.10.3.1.1.5.9.5.7.3]
b. Aug 1891
12
Howard Abbott
[1.2.3.10.3.1.1.5.9.5.7.4]
b. Jan 1896
10
Laura Dorcas Abbott
[1.2.3.10.3.1.1.5.9.6]
b. 31 Mar 1824 d. 14 Feb 1853
+
Alanson Paul Morton
b. Abt 1820 d. Mar 1872
10
Ruth Morrill Abbott
[1.2.3.10.3.1.1.5.9.7]
b. 15 Feb 1828 d. 30 Sep 1832
9
Aaron Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.10]
b. 4 Apr 1787 d. 17 Oct 1787
9
Fanny Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.11]
b. 11 Sep 1788 d. 1881
Stephen Sargent
b. 4 Feb 1785 d. 25 Dec 1825
10
Stephen Emery Sargent
[1.2.3.10.3.1.1.5.11.1]
b. 2 Sep 1809 d. 24 Jan 1893
Anna A Allbee
b. 1815 d. 1853
11
Ada Sargent
[1.2.3.10.3.1.1.5.11.1.1]
b. 1848
Elizabeth Cook
b. 2 Oct 1828
11
Ada Ellen Sargent
[1.2.3.10.3.1.1.5.11.1.2]
b. 11 Apr 1860
11
Emma Agnes Sargent
[1.2.3.10.3.1.1.5.11.1.3]
b. 20 Nov 1863 d. 20 Dec 1864
10
Fanny Maria Sargent
[1.2.3.10.3.1.1.5.11.2]
b. 4 Aug 1811 d. 25 Sep 1900
Benjamin Moore
b. 30 Dec 1800 d. 30 Jun 1853
11
Perlea Maria Moore
[1.2.3.10.3.1.1.5.11.2.1]
b. 30 Jun 1845 d. 8 Aug 1905
Frank Adolphus Derthick
b. 3 Jan 1844 d. 4 Jan 1922
12
Fanny Moore Derthick
[1.2.3.10.3.1.1.5.11.2.1.1]
b. 5 Feb 1867 d. 27 Nov 1962 [
=>
]
12
Mary Wilmot Derthick
[1.2.3.10.3.1.1.5.11.2.1.2]
b. 7 Sep 1869 d. 26 Dec 1953
12
Benjamin Moore Derthick
[1.2.3.10.3.1.1.5.11.2.1.3]
b. 27 Jun 1872 d. 29 Jun 1962
12
Frank Adelbert "Bert" Derthick
[1.2.3.10.3.1.1.5.11.2.1.4]
b. 29 Sep 1874 d. 23 Jul 1952
12
Perlea Samantha Derthick
[1.2.3.10.3.1.1.5.11.2.1.5]
b. 1 Mar 1879 d. 11 Dec 1954 [
=>
]
10
Susan Sargent
[1.2.3.10.3.1.1.5.11.3]
b. 18 Sep 1813 d. 1840
10
Ann K Sargent
[1.2.3.10.3.1.1.5.11.4]
b. 30 Nov 1815
+
Peter Warren
10
Betsey Sargent
[1.2.3.10.3.1.1.5.11.5]
b. 22 Nov 1817
George W Sawyer
b. 1813
11
George W Sargent
[1.2.3.10.3.1.1.5.11.5.1]
b. 12 Feb 1842
11
Stephen A Sargent
[1.2.3.10.3.1.1.5.11.5.2]
b. 13 Nov 1843
Caroline T Murphy
b. 30 Jan 1845
12
Stephen H Sargent
[1.2.3.10.3.1.1.5.11.5.2.1]
b. 3 Sep 1874
12
Sallie T Sargent
[1.2.3.10.3.1.1.5.11.5.2.2]
b. 15 Jan 1886
10
Roger Moses Sargent
[1.2.3.10.3.1.1.5.11.6]
b. 7 Sep 1824
Elizabeth Goodrich Spaulding
b. 27 Mar 1824 d. Abt 1895
11
Mary Ann Sargent
[1.2.3.10.3.1.1.5.11.6.1]
b. 1 Apr 1851 d. 25 Sep 1851
11
Roger Moses Sargent
[1.2.3.10.3.1.1.5.11.6.2]
b. 7 May 1852 d. 16 May 1852
11
Howard Merton Sargent
[1.2.3.10.3.1.1.5.11.6.3]
b. 24 Jul 1853
Wilhelmina Albertina Eichler
b. 26 Sep 1860
12
Howard C Sargent
[1.2.3.10.3.1.1.5.11.6.3.1]
b. 26 Sep 1880
12
Roger A Sargent
[1.2.3.10.3.1.1.5.11.6.3.2]
b. 18 Oct 1881 d. 1892
12
Bessie M Sargent
[1.2.3.10.3.1.1.5.11.6.3.3]
b. 26 Jun 1883 d. 5 Apr 1891
11
Clarence Spaulding Sargent
[1.2.3.10.3.1.1.5.11.6.4]
b. 29 Jul 1855 d. 21 Sep 1921
Mary Prescott Zelie
b. 4 Jul 1859
12
Constance M Sargent
[1.2.3.10.3.1.1.5.11.6.4.1]
b. 16 Apr 1887
12
Philip Clarence Sargent
[1.2.3.10.3.1.1.5.11.6.4.2]
b. 29 Nov 1888 d. 8 Dec 1951
12
Elizabeth M Sargent
[1.2.3.10.3.1.1.5.11.6.4.3]
b. 12 Oct 1890
12
Lawrence Prescott Sargent
[1.2.3.10.3.1.1.5.11.6.4.4]
b. 13 Jun 1893 d. 5 Nov 1970
12
Theodore Spaulding Sargent
[1.2.3.10.3.1.1.5.11.6.4.5]
b. 2 Oct 1895 d. 6 Jun 1984
11
Edwin Charlton Sargent
[1.2.3.10.3.1.1.5.11.6.5]
b. 10 Jun 1857 d. 9 Jan 1873
11
Fanny Elizabeth Sargent
[1.2.3.10.3.1.1.5.11.6.6]
b. 17 May 1859 d. 22 Jan 1864
11
Roger Moses Sargent
[1.2.3.10.3.1.1.5.11.6.7]
b. 30 Oct 1862 d. 1 Jan 1863
9
Frances Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.5.12]
b. 11 Sep 1788
8
Aaron Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6]
b. 28 Nov 1752 d. 11 Mar 1827
Betsy Ladd
b. 3 Sep 1756 d. 4 Jul 1836
9
True Worthy Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1]
b. 19 Jul 1774
Polly King
b. 30 Oct 1775
10
James King Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.1]
b. 12 Nov 1798 d. 6 Jan 1870
Eunice Brown
b. Abt 1800 d. 15 Apr 1888
11
Dana M Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.1.1]
b. 1823
Eliza
b. 1823
12
Mary Eliza Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.1.1.1]
b. 15 Oct 1845
12
Ellen Jennette Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.1.1.2]
b. 31 Jul 1848
12
Alice E Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.1.1.3]
b. Abt 1856
12
Unice E Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.1.1.4]
b. 1856
12
Gertrude S Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.1.1.5]
b. Aug 1863 [
=>
]
11
Mary J Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.1.2]
b. Abt 1827 d. 28 Feb 1893
William Burns Hutchins
b. 6 Jan 1823 d. 4 Feb 1899
12
Flora E Hutchins
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.1.2.1]
b. Abt 1848 [
=>
]
12
William J Hutchins
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.1.2.2]
b. 14 Jul 1850 d. 15 Oct 1921 [
=>
]
12
Dana Noyes Hutchins
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.1.2.3]
b. 17 Jan 1856 d. 15 May 1935 [
=>
]
12
Morton Marcus Hutchins
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.1.2.4]
b. 17 Jan 1859 d. 1 Oct 1932 [
=>
]
10
Delia Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.2]
b. 18 Aug 1800 d. 30 Oct 1822
Ormand Hunt
b. 4 Jan 1794 d. 10 Mar 1861
11
Simeon Hunt
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.2.1]
b. 7 Jul 1821 d. 4 Dec 1889
+
Ruby Cilley Train
b. 29 Jun 1824 d. 1 Feb 1914
11
Herman Hunt
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.2.2]
b. 14 Oct 1824 d. 16 Dec 1862
Elizabeth English
b. 14 Dec 1825
12
Ormond Fremont Hunt
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.2.2.1]
b. 4 Sep 1856
12
Elizabeth Mary Hunt
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.2.2.2]
b. 1860
12
Edson Hale Hunt
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.2.2.3]
b. 25 May 1853 d. 2 Feb 1937 [
=>
]
11
Mary E Hunt
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.2.3]
b. Abt 1828 d. 4 Mar 1832
11
Amanda Hunt
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.2.4]
b. 12 Dec 1832 d. 11 Apr 1910
10
Worth True Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.3]
b. 9 Jul 1805
10
Hiram King Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.4]
b. 9 Jun 1810 d. 1877
Susannah G Bourn
b. 28 Mar 1820
11
William Gilman Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.4.1]
b. 17 Jun 1842 d. 8 Feb 1927
+
Ruehaney Alice Romines
b. Abt 1844
11
Levi D Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.4.2]
b. 1844
11
Lucy Anna Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.4.3]
b. 15 May 1846
William Mathews
b. 28 Sep 1824 d. 29 Dec 1881
12
May Mathews
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.4.3.1]
b. 24 Feb 1878 d. 25 Jun 1956
11
Lansford Whiting Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.4.4]
b. 21 Apr 1847 d. 14 Oct 1919
Mary Jane Morrell
b. 30 May 1847 d. 4 Apr 1932
12
Ruby Eva Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.4.4.1]
b. 24 Jan 1869 d. 28 May 1907 [
=>
]
12
Charles Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.4.4.2]
b. 10 Oct 1871 d. 5 Dec 1871
12
Eula Mae Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.4.4.3]
b. 21 Jun 1873
12
Susie Caroline Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.4.4.4]
b. 8 Jul 1875 d. 25 Mar 1898
12
Charlotte Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.4.4.5]
b. 28 Nov 1877 d. 26 Mar 1918
12
Hattie Irene Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.4.4.6]
b. 28 Nov 1877 d. Mar 1918
12
Grace Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.4.4.7]
b. 18 Aug 1882 d. 26 Jun 1955 [
=>
]
12
Georgie Dolley Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.4.4.8]
b. 20 Nov 1885 d. 12 Mar 1888
12
Lansford Whiting Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.4.4.9]
b. 10 Dec 1887
11
Amanda B Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.4.5]
b. 1849
11
Lewis A Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.4.6]
b. 1854
11
Charles Eugene Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.4.7]
b. 20 Apr 1854
Alice McKilberry
b. Abt 1861 d. 28 Dec 1943
12
Eugenie Dott Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.4.7.1]
b. Abt 1883 d. Abt 1887
12
Edith Dwade Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.4.7.2]
b. Apr 1887
12
Eythle G Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.4.7.3]
b. 1888
12
Leroy Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.4.7.4]
b. Sep 1890
12
Martha Louisa Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.4.7.5]
b. Apr 1894 [
=>
]
11
Wesley F Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.4.8]
b. 1856
11
Ruby Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.4.9]
b. 1859
11
Etta "Mary" Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.4.10]
b. 12 Jun 1866 d. 23 Jun 1909
+
John H Shriner
b. 12 Jul 1858 d. 19 Feb 1927
10
Nathaniel King Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.5]
b. 9 Oct 1811 d. 30 Mar 1891
Susan Sargent
b. 7 Aug 1813 d. 8 Nov 1871
11
Delia A Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.5.1]
b. 12 Nov 1834 d. 13 Dec 1919
William Mercer
b. 12 Oct 1824 d. 30 Sep 1900
12
Charles Emmett Mercer
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.5.1.1]
b. 2 Nov 1853 d. 10 May 1919 [
=>
]
12
Benjamin K Mercer
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.5.1.2]
b. 13 Jul 1862 d. 30 Jul 1871
12
Thaddeus Guy Mercer
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.5.1.3]
b. 25 Jul 1865 d. 21 Mar 1944 [
=>
]
11
Emily K Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.5.2]
b. 9 Apr 1837 d. 5 Oct 1921
Thomas F Mosher
b. 2 Aug 1829 d. 8 Jul 1903
12
Berta Mosher
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.5.2.1]
b. 10 Apr 1859 d. 28 Jun 1862
12
Metta A Mosher
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.5.2.2]
b. 8 Dec 1860 d. 23 Mar 1934
11
Abner K Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.5.3]
b. 23 Jul 1841 d. 22 May 1920
Emily R Clement
b. Jun 1845
12
Albert K Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.5.3.1]
b. 7 Dec 1870
12
Esma Mary Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.5.3.2]
b. Jun 1875
12
William Clement Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.5.3.3]
b. 8 Oct 1879 d. 1 Aug 1973
+
Jane Ann "Jennie" Newman
b. 1843
11
Sarah Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.5.4]
b. Jun 1844 d. 27 Aug 1926
Philip Taylor
b. 11 Aug 1839 d. 8 May 1927
12
Robert K Taylor
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.5.4.1]
b. May 1867
11
Marietta "Etta" Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.5.5]
b. 1848 d. 7 Apr 1878
John Sutherland Malcomson
b. 21 Jan 1826 d. 3 Jul 1898
12
Alexander King Malcomson
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.5.5.1]
b. 24 Nov 1870 d. 5 Jun 1942 [
=>
]
12
Frank E Malcomson
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.5.5.2]
b. 15 Oct 1872 d. 11 Jul 1893
12
John Sutherland Malcomson
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.5.5.3]
b. 16 Aug 1874 d. 25 Mar 1933
12
Harry Malcomson
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.5.5.4]
b. Apr 1876 d. 1 Oct 1876
11
Charles Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.5.6]
b. May 1850 d. 2 Jan 1929
11
Benjamin Franklin Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.5.7]
b. 21 Jan 1852 d. 12 Jul 1933
Helen Viola Gunnison
b. 20 Apr 1856 d. 10 Mar 1925
12
John Homer Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.5.7.1]
b. 14 Feb 1877 d. 1 Dec 1957
12
May E Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.5.7.2]
b. Jan 1879
11
Frances Adelade Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.5.8]
b. 6 Aug 1854 d. 8 Apr 1925
Charles D Parks
b. Sep 1850 d. 9 Dec 1934
12
Earl K Parks
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.5.8.1]
b. 29 Aug 1876 d. 21 Sep 1945
12
Iva Louise Parks
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.5.8.2]
b. 24 Jun 1880 d. Jul 1963 [
=>
]
11
Ezra William Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.5.9]
b. Oct 1857 d. 24 Aug 1931
Sarah Jane Aldrich
b. 22 Jan 1840 d. 10 Mar 1926
11
Bessie May Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.5.10]
b. 5 Nov 1872 d. 15 Aug 1918
Ralph Allen Youngs
b. 22 Jun 1867 d. 16 Apr 1936
12
Dorotha Alice Youngs
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.5.10.1]
b. 13 May 1898 d. 25 Apr 1972
12
Jessie Jane Youngs
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.5.10.2]
b. 14 Dec 1899 d. 20 Feb 1945
12
Ralph Clyde Youngs
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.5.10.3]
b. 16 Mar 1903 d. 11 Mar 1972
12
Alan King Youngs
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.5.10.4]
b. 16 Apr 1905 d. 5 Sep 1976
12
Carl Alfred Youngs
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.5.10.5]
b. 2 May 1908 d. 8 Aug 2001
11
Jessie King Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.5.11]
b. 27 Jul 1874 d. 26 May 1957
Lewis Kelly
b. 1861
12
Dwight N Kelly
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.5.11.1]
b. 3 Jan 1898 d. Aug 1968
12
Ezra Ford Kelly
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.5.11.2]
b. 1904 d. 11 Feb 1966
11
Bertha Edna Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.5.12]
b. 24 May 1876 d. 10 Apr 1928
11
Flora Adell Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.5.13]
b. 19 Jul 1880 d. 12 May 1919
Orville Clyde Allebach
b. 25 Feb 1878 d. 14 Jul 1962
12
Hobart King Benjamin Allebach
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.5.13.1]
b. 11 Mar 1903 d. 20 Jun 1989
12
Sarah Ruth Allebach
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.5.13.2]
b. 9 Jan 1906 d. Sep 1973
10
William K Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.1.6]
b. Abt 1815
9
Aaron Noyes, Jr
[1.2.3.10.3.1.1.6.2]
b. 3 Apr 1776 d. 16 Feb 1813
Elizabeth "Betsy" King
b. 5 Jun 1777 d. 23 Oct 1833
10
Laura K Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.2.1]
b. 14 Jun 1799 d. 11 Dec 1844
Aaron Noyes
b. 30 Sep 1790 d. 21 Oct 1820
11
Aaron G Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.2.1.1]
b. Abt 1824
+
Joseph F Lamson
b. 1793 d. Oct 1869
10
Ira Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.2.2]
b. 25 Apr 1801 d. 19 Sep 1802
10
Herman Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.2.3]
b. 28 Apr 1803 d. 31 Dec 1876
Sarah W Powell
b. 22 May 1813 d. 27 Jul 1900
11
Mary E Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.2.3.1]
b. 6 Mar 1835 d. Apr 1907
+
Steward Drew
b. Abt 1831
11
Laura P Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.2.3.2]
b. 22 Jul 1837 d. Bef 1860
11
Philo G Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.2.3.3]
b. 4 Jul 1840 d. 4 Nov 1861
11
John Powell Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.2.3.4]
b. 15 Sep 1842 d. 14 May 1924
Lucy Ann Merry
b. 1845
12
Egbert S Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.2.3.4.1]
b. Sep 1867 d. 25 May 1875
12
Jessie C Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.2.3.4.2]
b. 30 Nov 1870
12
Bertha A Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.2.3.4.3]
b. 30 Jun 1873
12
Emily M Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.2.3.4.4]
b. 7 Mar 1876
12
Ralph M Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.2.3.4.5]
b. 19 Feb 1877
11
Almon H Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.2.3.5]
b. 15 Dec 1844 d. 14 Mar 1925
Louisa Rozilla Brown
b. 20 Dec 1846 d. 6 Aug 1891
12
Lillian R Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.2.3.5.1]
b. 29 Jan 1868
12
George Herman Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.2.3.5.2]
b. 11 Apr 1870 d. 16 Dec 1943 [
=>
]
12
John Albert Edward Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.2.3.5.3]
b. 22 Jul 1873
12
Hattie Alberta Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.2.3.5.4]
b. 1 Aug 1875
12
Willie F Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.2.3.5.5]
b. 12 Apr 1878 d. 22 Feb 1885
12
Charles Hugh Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.2.3.5.6]
b. 22 Jul 1880 d. 24 Feb 1942
12
Carlos E Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.2.3.5.7]
b. 4 Jul 1882 d. 28 Oct 1893
12
Woodburn A Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.2.3.5.8]
b. 12 Aug 1886
Mary A Balduke
b. Abt 1860
12
Woodburn Alton Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.2.3.5.9]
b. 12 Aug 1896 d. Jul 1963
12
Arthur Dewey Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.2.3.5.10]
b. 9 Aug 1898 d. Jan 1963
12
Effie Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.2.3.5.11]
b. 26 Jun 1900
+
Fanny Steer
b. Abt 1886
11
Roxana Saloma Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.2.3.6]
b. 1 Aug 1847 d. 1931
David Dillabough
b. Abt 1840 d. 1911
12
Edgar Moses Dillabaugh
[1.2.3.10.3.1.1.6.2.3.6.1]
b. 6 Feb 1871 [
=>
]
12
Gertrude Dillabaugh
[1.2.3.10.3.1.1.6.2.3.6.2]
b. 11 Jul 1872 d. 1916
12
John A Dillabaugh
[1.2.3.10.3.1.1.6.2.3.6.3]
b. 19 Feb 1874 d. 28 Feb 1874
12
Almond D Dillabaugh
[1.2.3.10.3.1.1.6.2.3.6.4]
b. 3 Sep 1877 d. 1902
12
Frank Dillabaugh
[1.2.3.10.3.1.1.6.2.3.6.5]
b. 2 Sep 1879
12
Ira B Dillabaugh
[1.2.3.10.3.1.1.6.2.3.6.6]
b. 12 Feb 1882 d. 7 Apr 1935 [
=>
]
12
Jessie Dillabaugh
[1.2.3.10.3.1.1.6.2.3.6.7]
b. 15 Aug 1886
11
Harriet C Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.2.3.7]
b. 10 Jul 1852 d. 19 May 1881
11
Abbie A Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.2.3.8]
b. 27 Aug 1855
+
David Dustin
b. Abt 1851
10
Almon Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.2.4]
b. 9 Mar 1805 d. 10 Apr 1873
10
Mary Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.2.5]
b. 8 May 1807 d. 10 Jun 1834
9
Lydia Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.3]
b. 22 Aug 1778 d. 5 Feb 1869
Nathaniel King
b. 4 May 1767 d. 18 Oct 1857
10
Deliverance "Dilly" King
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.1]
b. 5 Jul 1795 d. 23 Apr 1873
James Goodwin
b. 1793
11
Lydia King Goodwin
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.1.1]
b. 17 Mar 1815 d. 11 Aug 1905
William L Endicott
b. 20 Aug 1813
12
George W Endicott
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.1.1.1]
b. 1841 [
=>
]
12
Henry W Endicott
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.1.1.2]
b. 10 Jan 1845 d. 21 Sep 1886 [
=>
]
11
Dilly Goodwin
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.1.2]
b. 7 Oct 1816 d. 25 Aug 1854
Lorenzo D Moxley
b. 12 May 1810 d. 28 Jan 1901
12
Azro George Moxley
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.1.2.1]
b. 19 May 1839 d. 6 Mar 1877 [
=>
]
12
Lester Moxley
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.1.2.2]
b. 1847
11
Julia King Goodwin
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.1.3]
b. 17 Dec 1818 d. 30 Nov 1898
Aaron Madison Gould
b. 12 Jul 1816 d. 21 May 1884
12
Esther A Gould
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.1.3.1]
b. 1843 d. 18 Mar 1890
12
Lorenzo Wellington Gould
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.1.3.2]
b. Abt 1843 d. 29 Nov 1862
12
Laurentia Gould
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.1.3.3]
b. Nov 1844
12
Julius Cornelius Gould
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.1.3.4]
b. 17 Jun 1847 d. 8 Jun 1907
12
George Washington Gould
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.1.3.5]
b. 8 Nov 1850 d. 23 Jul 1914 [
=>
]
12
William Byron Gould
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.1.3.6]
b. 1857
11
James K Goodwin
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.1.4]
b. 26 Jun 1821
Malvina Hayward
b. 20 Jan 1827 d. 19 Jan 1909
12
Henry E Goodwin
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.1.4.1]
b. 1856
12
Mabel Dyette Goodwin
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.1.4.2]
b. 19 Oct 1868 [
=>
]
10
Lydia King
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.2]
b. 13 Mar 1797 d. 4 Dec 1893
Stephen Herrick
b. 19 Feb 1795 d. 19 Mar 1885
11
Eliza King Herrick
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.2.1]
b. 14 Oct 1820 d. 18 Mar 1897
Chester Pierce
b. 19 Oct 1814 d. 29 Jul 1842
12
Arthur L Pierce
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.2.1.1]
b. 20 Sep 1841 d. 10 Oct 1841
Samuel L Warren
b. 26 Nov 1810 d. 25 Mar 1864
12
Josiah H Warren
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.2.1.2]
b. 3 Sep 1843 d. 17 Aug 1917 [
=>
]
12
Julia R Warren
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.2.1.3]
b. 21 Nov 1844 d. 6 Oct 1904 [
=>
]
12
Jerome A Warren
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.2.1.4]
b. Abt 1846 d. 11 Dec 1863
12
Lorenzo Dow Warren
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.2.1.5]
b. Abt 1849 [
=>
]
12
Addison Warren
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.2.1.6]
b. 1852
12
Herbert P Warren
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.2.1.7]
b. 1854 [
=>
]
12
Elmer Warren
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.2.1.8]
b. Abt 1856 d. 1864
12
Lelah Emily Warren
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.2.1.9]
b. Abt 1859 d. 19 Nov 1859
12
Eveline E Warren
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.2.1.10]
b. Abt 1864 d. 12 Jul 1864
11
Nathaniel King Herrick
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.2.2]
b. 3 Nov 1822 d. 30 Jan 1891
Harriet Jane Foster
b. 14 Aug 1827 d. 1 Feb 1907
12
Carrie E Herrick
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.2.2.1]
b. 1852 d. Mar 1931 [
=>
]
12
Charles H Herrick
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.2.2.2]
b. 17 Dec 1856 d. 12 Jun 1859
11
Emily Rosette Herrick
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.2.3]
b. 23 Nov 1825 d. 29 Apr 1848
11
Harriet Perlina Herrick
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.2.4]
b. 26 Feb 1829 d. 29 Mar 1868
Abraham Sampson Adams
b. 14 Aug 1819 d. 25 Sep 1903
12
Minnie M Adams
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.2.4.1]
b. Abt 1870 [
=>
]
12
George Herrick Adams
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.2.4.2]
b. 13 Jan 1850 [
=>
]
12
Julius Edwin Adams
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.2.4.3]
b. 9 Feb 1848 d. 27 May 1873
12
Mary Ellen Adams
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.2.4.4]
b. 7 Feb 1852 [
=>
]
12
Alma Rosetta Adams
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.2.4.5]
b. 3 Oct 1855 d. 22 Jan 1923 [
=>
]
12
Harriet V Adams
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.2.4.6]
b. 29 Oct 1859
11
Laura Jane Herrick
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.2.5]
b. 11 Jun 1831 d. 1894
John McDermid
b. Abt 1827 d. 15 May 1874
12
Alice McDermid
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.2.5.1]
b. 17 Feb 1856 d. 16 Apr 1917 [
=>
]
12
Jennie K McDermid
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.2.5.2]
b. 15 Aug 1861 d. Jun 1881
+
Robert R Bunnell
b. Abt 1819 d. 19 Mar 1885
11
Nancy Janetta Herrick
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.2.6]
b. 21 Mar 1834 d. Nov 1916
Arthur L McDermid
b. Abt 1830 d. Apr 1867
12
Emma McDermid
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.2.6.1]
b. 1855 d. 1869
12
Annette Isabelle McDermid
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.2.6.2]
b. 9 Aug 1858 [
=>
]
12
Charles A McDermid
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.2.6.3]
b. 31 Mar 1865
+
Frederick A Richardson
b. Abt 1830 d. 18 Apr 1889
11
Lydia Ann Herrick
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.2.7]
b. 3 Mar 1838 d. 12 Feb 1899
+
Heman J Taplin
b. Abt 1834 d. 28 Oct 1902
11
Alma Rosetta Herrick
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.2.8]
b. 24 Mar 1842 d. 7 Sep 1913
Volney Voltaire Vaughn
b. 30 Dec 1840 d. 8 Nov 1886
12
Mabel L Vaughn
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.2.8.1]
b. 2 Aug 1867 d. 17 Apr 1877
12
Wilmer Herrick Vaughn
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.2.8.2]
b. 2 Jan 1874 d. 30 Jul 1941
12
Ida Alma Vaughn
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.2.8.3]
b. 25 Jan 1876 d. 18 Sep 1958 [
=>
]
12
Frank Waldo Vaughn
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.2.8.4]
b. 5 Dec 1879 d. 6 Dec 1956
10
Hanna Harvey King
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.3]
b. 17 Feb 1799 d. 18 Jun 1838
Joseph F Lamson
b. 1793 d. Oct 1869
11
Susanna Lampson
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.3.1]
b. 14 Dec 1818
11
Nancy Lamson
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.3.2]
b. 1820 d. 1832
11
Joshua F Lamson
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.3.3]
b. 3 Oct 1822 d. 1 Mar 1886
11
Nathaniel King Lamson
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.3.4]
b. 1824 d. Abt 1898
11
Joseph Lampson
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.3.5]
b. 1 Feb 1828 d. 1910
11
Theodore Cook Lamson
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.3.6]
b. 18 Jul 1831 d. 3 Jan 1911
10
Hatty King
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.4]
b. 8 Mar 1801 d. 22 Aug 1833
Howard Moulton
b. 5 Jan 1792 d. 6 Aug 1859
11
Nathaniel L Moulton
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.4.1]
b. Abt 1822
11
Eliza K Moulton
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.4.2]
b. Abt 1824 d. Aft 1860
Lewis Gay Spencer
b. 12 Oct 1823 d. 27 Jul 1860
12
William P Spencer
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.4.2.1]
b. Abt 1847 d. 2 Feb 1907 [
=>
]
12
Charles M Spencer
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.4.2.2]
b. Abt 1847
12
John Spencer
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.4.2.3]
b. Abt 1853 d. 18 Feb 1855
12
Annie L Spencer
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.4.2.4]
b. Aug 1859 [
=>
]
11
Nancy K Moulton
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.4.3]
b. Abt 1828
John C Huntington
b. 26 Dec 1827
12
Marion A Huntington
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.4.3.1]
b. 22 Jun 1850
12
Ellen Eliza Huntington
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.4.3.2]
b. 7 Mar 1853 d. 7 Feb 1934
10
Abigail King
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.5]
b. 13 Aug 1803 d. 13 Oct 1858
William Putnam
b. 5 Oct 1799
11
Son Putnam
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.5.1]
b. Aug 1827 d. 29 Aug 1827
11
Abijah M Putnam
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.5.2]
b. Abt 1830 d. 20 Aug 1832
11
Nathaniel K Putnam
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.5.3]
b. 3 Jun 1832
Thirza A Huntington
b. 12 Jul 1837
12
Nellie Emeline Putnam
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.5.3.1]
b. 17 Mar 1862 [
=>
]
12
Wellie Huntington Putnam
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.5.3.2]
b. 16 Jan 1867
11
Lydia Ann Putnam
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.5.4]
b. 13 Aug 1834
Stephen Folsom Drew
b. 12 Oct 1821
12
William P Drew
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.5.4.1]
b. 24 Nov 1860
12
Charles F Drew
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.5.4.2]
b. 4 Feb 1863
11
Emeline N Putnam
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.5.5]
b. 23 Jun 1836
Edwin Fisher
b. 15 Jun 1825 d. 17 Aug 1892
12
Abbie May Fisher
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.5.5.1]
b. 20 Jul 1865 d. 7 Mar 1934 [
=>
]
12
Edwin Putman Fisher
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.5.5.2]
b. 10 Nov 1867 d. 16 May 1928
12
William Marcus Fisher
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.5.5.3]
b. 8 Nov 1869
12
Fannie Maud Fisher
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.5.5.4]
b. 23 Oct 1871 d. 24 Nov 1894
11
Sarah Jane Putnam
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.5.6]
b. Abt 1839 d. 29 May 1842
10
Eliza Harvey King
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.6]
b. 9 Jun 1807 d. Oct 1900
John Hunt
b. 1 Aug 1802 d. 3 Oct 1887
11
Daughter Hunt
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.6.1]
b. 9 Feb 1829 d. 9 Feb 1829
11
Laurentio Gonsalvi Hunt
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.6.2]
b. 23 Oct 1830 d. 12 Jan 1919
Henrietta C Hill
b. 1837
12
Lucius W Hunt
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.6.2.1]
b. 1855 d. 1862
12
John Hunt
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.6.2.2]
b. 1857 d. 1866
12
Thadeus S Hunt
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.6.2.3]
b. 1866
12
Fred S Hunt
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.6.2.4]
b. 1867
12
Jessie Hunt
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.6.2.5]
b. 1872
12
Mark Hunt
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.6.2.6]
b. 15 May 1874 [
=>
]
11
Sarah Aurora Hunt
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.6.3]
b. 22 Sep 1832 d. 8 Jan 1901
John Earl
b. 17 Sep 1820 d. 3 Apr 1907
12
Mollie Earl
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.6.3.1]
b. 9 Feb 1859 [
=>
]
12
Frank Earl
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.6.3.2]
b. 1864 [
=>
]
12
Bessie A Earl
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.6.3.3]
b. 12 Aug 1874 [
=>
]
12
Sarah Alice Earl
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.6.3.4]
b. 17 Aug 1876 d. 24 Jan 1930
11
Harty H Hunt
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.6.4]
b. 20 Oct 1834 d. 4 Nov 1894
Jonathan J Woodman
b. 24 May 1825 d. 13 Jul 1904
12
Lucius K Woodman
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.6.4.1]
b. 22 Mar 1862
11
Nathaniel King Hunt
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.6.5]
b. 23 Jan 1837 d. 20 Dec 1924
Annette E Spencer
b. Abt 1842
12
Lena Annette Hunt
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.6.5.1]
b. 19 Oct 1863 d. 19 Mar 1902 [
=>
]
12
George Spencer Hunt
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.6.5.2]
b. 31 Mar 1866 d. 30 Jun 1935 [
=>
]
+
Rosetta Mix
b. 1857 d. 16 May 1916
11
Lydia King Hunt
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.6.6]
b. 26 Jul 1840
+
William Dole
b. Feb 1833
11
Simeon Hunt
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.6.7]
b. 29 Jan 1843 d. 15 Apr 1859
11
Garretta Hunt
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.6.8]
b. 13 Mar 1845
11
Eliza A Hunt
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.6.9]
b. 12 Dec 1847
Edson F Stevens
b. 1848 d. 23 Jan 1930
12
Lucinda L Stevens
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.6.9.1]
b. 1873
12
E Blanche Stevens
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.6.9.2]
b. 1878
11
John Hunt
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.6.10]
b. 9 Jun 1850 d. 1908
Lizzie Cornellia Overacker
b. 20 Mar 1852
12
Son Hunt
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.6.10.1]
b. Abt 1887
12
April Hunt
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.6.10.2]
b. Mar 1889
12
Mary R Hunt
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.6.10.3]
b. 11 Jul 1891
12
Marvel Ruth Hunt
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.6.10.4]
b. 11 Jul 1891 d. 8 Nov 1971 [
=>
]
10
Sally Hacket King
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.7]
b. 11 Apr 1809 d. 28 Nov 1890
Moody Smith
b. 9 Sep 1801
11
Janet L Smith
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.7.1]
b. Abt 1833
11
Laura A Smith
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.7.2]
b. Abt 1835
10
Phillip King
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.8]
b. 4 Jul 1811
10
Nancy Folsom King
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.9]
b. 30 Oct 1813 d. 17 Jan 1906
Jeremiah Brown
b. Abt 1810 d. 14 Oct 1883
11
Son Brown
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.9.1]
b. 1836 d. 4 Nov 1836
11
Son Brown
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.9.2]
b. 1837 d. 27 Nov 1840
10
Daniel P King
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.10]
b. Abt 1815
10
Harvey King
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.11]
b. 22 Mar 1818
Jane Lyman
b. 7 Aug 1816 d. 11 Apr 1852
11
Jane Lyman King
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.11.1]
b. 10 Aug 1845 d. 14 May 1921
+
Benjamin Wadley Hoyt
b. 18 Jun 1843
11
Fanny Brunar King
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.11.2]
b. 6 Sep 1849
10
Aaron Nathaniel King
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.12]
b. 1 Jul 1820 d. 13 Sep 1901
Eliza B Nutter
b. 10 Mar 1823 d. 24 Jul 1876
11
Heber Aaron King
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.12.1]
b. 14 Mar 1843 d. 2 Dec 1869
11
Millard Taylor King
[1.2.3.10.3.1.1.6.3.12.2]
b. 20 Aug 1848 d. 13 Dec 1916
+
Ellen Eliza Huntington
b. 7 Mar 1853 d. 7 Feb 1934
9
Mehitable Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.4]
b. 18 Jan 1780 d. 11 Jan 1852
George King
b. 15 Nov 1773 d. 2 Oct 1835
10
Abigail King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.1]
b. 10 Jun 1800 d. 25 Aug 1887
Moses Wilds
b. 8 Oct 1790 d. 1 Nov 1879
11
Mary Wilds
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.1.1]
b. 14 Feb 1818 d. 21 Apr 1895
Nathan A Smith
b. 12 Feb 1820 d. 11 Apr 1888
12
Lydia Smith
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.1.1.1]
b. 4 Aug 1847 d. 22 Nov 1937
12
Carlos William Smith
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.1.1.2]
b. 18 Aug 1852 d. 2 May 1928 [
=>
]
11
Lydia Wilds
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.1.2]
b. 4 Feb 1820
Thomas Jefferson Dickey
b. 10 Dec 1808 d. 1 Feb 1881
12
Henry Dickey
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.1.2.1]
b. 1842 d. 1913
12
Clara Ellen Dickey
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.1.2.2]
b. 5 Apr 1849 d. 15 Jun 1877 [
=>
]
12
Thomas Jefferson Dickey, Jr
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.1.2.3]
b. 26 Jan 1850 d. 26 Mar 1865
12
Rose A Dickey
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.1.2.4]
b. 22 Jan 1854 d. 22 Mar 1874
12
Lillian Dickey
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.1.2.5]
b. 29 Sep 1859
11
Mehitable "Hittie" Wilds
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.1.3]
b. 17 Jun 1826 d. 1 Nov 1910
Richard Peckham Church
b. 27 Nov 1819 d. 27 Nov 1897
12
George King Church
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.1.3.1]
b. 1 May 1844 d. 1937 [
=>
]
12
Lydia Church
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.1.3.2]
b. 1846
12
Flora Church
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.1.3.3]
b. Abt 30 Apr 1856 d. 31 Aug 1859
12
Floran A Church
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.1.3.4]
b. 15 May 1859 d. 14 Dec 1931 [
=>
]
11
Sally J Wilds
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.1.4]
b. Abt 1828
Christopher Columbus Payne
b. 28 Sep 1828 d. 1 Dec 1883
12
Wilson A Payne
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.1.4.1]
b. 1851 d. 1926
12
Abbie S Payne
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.1.4.2]
b. 1854 [
=>
]
12
Dwight C Payne
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.1.4.3]
b. May 1868 d. 4 Apr 1870
11
Cynthia C Wilds
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.1.5]
b. 30 Aug 1831 d. 26 May 1930
+
Samuel G Saville
b. 28 Nov 1828 d. 1 Dec 1918
10
Hiram King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.2]
b. 14 May 1802 d. 11 Jul 1862
Sally Colby
b. 6 May 1800 d. 19 Oct 1871
11
Joshua King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.2.1]
b. 3 Aug 1825
11
Caroline King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.2.2]
b. 18 Jun 1827 d. 23 Mar 1905
Huntley Jackson
b. 7 May 1824 d. 1914
12
Mary Jackson
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.2.2.1]
b. 8 Oct 1848 [
=>
]
12
Nancy Jackson
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.2.2.2]
b. 15 Jul 1850 [
=>
]
11
Corodon N King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.2.3]
b. 6 Sep 1829 d. 1900
+
Sarah Jane Mowe
b. Abt 1830
11
Calista King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.2.4]
b. 10 Apr 1833
Benjamin H Wood
b. 1833
12
Eva Belle Wood
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.2.4.1]
b. Sep 1866
12
Charles Wood
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.2.4.2]
[
=>
]
11
Rosalthie King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.2.5]
b. 1 Apr 1836 d. 17 May 1865
Thomas Hazen Minard
b. Abt 1835
12
Rosalthie Minard
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.2.5.1]
b. 5 Feb 1865
11
Adelia King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.2.6]
b. 12 May 1839 d. 25 Dec 1915
+
George N Rice
b. 18 Feb 1830 d. 25 Jan 1915
11
Julia A King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.2.7]
b. 5 Apr 1843 d. 1 Aug 1930
George Emery Newton
b. 26 Sep 1836 d. 8 May 1919
12
Alberta Edna Newton
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.2.7.1]
b. 12 Dec 1865 [
=>
]
12
Ralph Waldo Newton
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.2.7.2]
b. 28 Mar 1875 [
=>
]
10
Sarah King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.3]
b. 19 Jan 1804 d. 13 Mar 1866
William Wilds
b. 16 Jan 1800 d. 16 Feb 1876
11
Diantha Wilds
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.3.1]
b. 2 Dec 1831
Aaron Bunnell Sargent
b. 7 Jun 1829
12
Mary S Sargent
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.3.1.1]
b. 24 Jun 1852 d. 19 Apr 1902 [
=>
]
11
Diana Wilds
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.3.2]
b. 2 Dec 1831
Almon Richardson Thurston
b. Abt 1829
12
Emma Thurston
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.3.2.1]
b. 1858
12
Claira C. Thurston
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.3.2.2]
b. 28 Jun 1859
11
Merrill F Wilds
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.3.3]
b. 23 Dec 1832 d. 27 Jul 1903
Satira Bradford
b. Abt 10 Apr 1842 d. 20 Oct 1897
12
Etta May Wilds
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.3.3.1]
b. 21 Jun 1866 d. 22 Dec 1933 [
=>
]
12
Rosie Emma Wilds
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.3.3.2]
b. 21 Apr 1870 d. 27 Dec 1903 [
=>
]
11
Sarah King Wilds
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.3.4]
b. 2 May 1834 d. 29 Jan 1906
Charles Poole
b. Abt 1830 d. 27 Jan 1906
12
Edward C Poole
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.3.4.1]
b. 1 Nov 1854
12
Ada M Poole
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.3.4.2]
b. 9 Nov 1856 d. 18 Jul 1890
12
Gertrude S Poole
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.3.4.3]
b. 21 Jun 1863 [
=>
]
12
William Everett Poole
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.3.4.4]
b. 13 Jun 1867
11
Louisa Wilds
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.3.5]
b. 13 Dec 1838 d. 26 Dec 1893
Alexander Franklin Hayward
b. 11 Apr 1836 d. 4 Jul 1911
12
Ernest Franklin Hayward
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.3.5.1]
b. 1 Oct 1874 d. 17 May 1951 [
=>
]
11
Almira Elizabeth Wilds
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.3.6]
b. 11 Sep 1840 d. 21 Feb 1906
Charles Howard Beede
b. 3 Aug 1839 d. 4 Apr 1911
12
Clinton Horatio Beede
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.3.6.1]
b. 11 Jan 1865 d. 19 Mar 1942 [
=>
]
12
Caroline Adell Beede
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.3.6.2]
b. 28 Apr 1868 d. 12 Sep 1934 [
=>
]
12
Rose Emma Beede
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.3.6.3]
b. 1 Nov 1871 d. 17 Nov 1919 [
=>
]
12
Bertha Alice Beede
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.3.6.4]
b. 22 Oct 1877 d. 27 May 1932 [
=>
]
12
Ada May Beede
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.3.6.5]
b. 26 May 1881 d. 13 Aug 1881
11
John K Wilds
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.3.7]
d. 5 Feb 1909
Eunice M Dexter
b. 17 Feb 1831 d. 29 May 1898
12
Elwin Aaron Wilds
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.3.7.1]
b. 9 Dec 1859 d. 2 Jul 1932 [
=>
]
+
Alice Curtis
b. Abt 1850
10
Susan King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.4]
b. 2 Aug 1807 d. 17 Oct 1887
Hezekiah Felch Dickey
b. 28 Sep 1809 d. 12 Oct 1895
11
Cyrus F Dickey
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.4.1]
b. 24 Jun 1832 d. 28 Nov 1892
Mary J Currier
b. 31 Aug 1833 d. 19 Sep 1869
12
Addie C Dickey
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.4.1.1]
b. 1856 d. 1920 [
=>
]
12
Frank Dickey
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.4.1.2]
b. 1860
+
Clarissa Smiley
b. 20 Oct 1838 d. 4 May 1912
11
Lucinda D Dickey
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.4.2]
b. 28 Jul 1837 d. 4 Sep 1898
Rufus L Farrar
b. 14 Nov 1828 d. 5 Sep 1915
12
Hezekiah Dickey Farrar
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.4.2.1]
b. 19 Aug 1861 d. 21 Jan 1929 [
=>
]
12
Susie E Farrar
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.4.2.2]
b. 5 Nov 1859 d. 17 Jul 1898
12
Howard J Farrar
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.4.2.3]
b. 26 Mar 1865 [
=>
]
12
Ina M Farrar
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.4.2.4]
b. 23 May 1867 d. 13 Feb 1911
12
Mary E Farrar
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.4.2.5]
b. 30 Mar 1870
12
Sadie M Farrar
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.4.2.6]
b. 14 Aug 1873
11
Alvina Dickey
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.4.3]
b. 6 Oct 1839 d. 2 Dec 1927
John Walter Burgin
b. 10 Dec 1843 d. 31 Jul 1920
12
George Walter Burgin
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.4.3.1]
b. 27 Jan 1872 d. 27 Oct 1903 [
=>
]
12
Frank Burgin
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.4.3.2]
b. 28 Oct 1877 d. 20 Jan 1905
10
Betsy N King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.5]
b. 12 Mar 1810 d. 9 Apr 1888
Robert F Goodwin
b. 8 Oct 1809 d. 4 Jun 1888
11
Isaac H Goodwin
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.5.1]
b. 3 Oct 1844 d. 17 Jun 1913
Ann Jane Craik
b. Dec 1847 d. 1942
12
Robertie M Goodwin
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.5.1.1]
b. 15 Apr 1874 d. 12 Jul 1966
12
Nina Goodwin
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.5.1.2]
b. 1 May 1877
12
Victor E Goodwin
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.5.1.3]
b. 11 May 1879
12
William Robert Goodwin
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.5.1.4]
b. 1 Jan 1886 d. 7 Jun 1977 [
=>
]
11
George Francis Goodwin
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.5.2]
b. 12 Jan 1849 d. 19 Jan 1918
Katie Sophie Winters
b. 22 Aug 1852 d. 8 Aug 1922
12
George Oliver Goodwin
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.5.2.1]
b. 1880 [
=>
]
12
Harry Winters Goodwin
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.5.2.2]
b. 12 Aug 1883 d. Jul 1964 [
=>
]
12
Robert Judson Goodwin
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.5.2.3]
b. 3 Jul 1888
10
Sophia King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.6]
b. 18 Jun 1812 d. 10 Dec 1815
10
Field King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.7]
b. 23 Mar 1814 d. 10 Dec 1815
10
George King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.8]
b. 16 Jan 1816 d. 1 Nov 1872
Diana Darling
b. 13 Oct 1811 d. 29 Apr 1845
11
Almira Myra King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.8.1]
b. 28 Mar 1837 d. 27 Sep 1900
11
Lucy A King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.8.2]
b. 24 Apr 1839 d. 1884
+
Edson S Mills
b. 26 Jun 1825 d. 1911
11
Charles Cyrus King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.8.3]
b. 13 Oct 1840 d. 30 Nov 1918
Julia Ann Wright
b. 14 May 1843 d. 4 Jul 1885
12
George Elihu King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.8.3.1]
b. 2 Aug 1866 d. Jul 1943 [
=>
]
12
Chester Reuben King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.8.3.2]
b. 2 May 1869 d. 28 Apr 1920 [
=>
]
12
Addie Elizabeth King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.8.3.3]
b. 18 Nov 1875 [
=>
]
11
Diana Elizabeth King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.8.4]
b. 31 Dec 1842 d. 10 Oct 1898
Ira M Sawyer
b. 28 Jul 1837 d. 29 Dec 1918
12
Jane Elizabeth Sawyer
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.8.4.1]
b. 13 Mar 1869 [
=>
]
12
Myra Loanda Sawyer
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.8.4.2]
b. 13 Mar 1869 d. 17 Oct 1908
12
Otis George Sawyer
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.8.4.3]
b. 25 Oct 1870
12
Clara Lucinda Sawyer
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.8.4.4]
b. 22 Sep 1873 [
=>
]
11
Chester Dickey King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.8.5]
b. 2 Nov 1844 d. 13 Feb 1864
11
Son King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.8.6]
b. Abt 1846 d. 1846
Rebecca Burbank
b. 1 Feb 1817 d. 22 Aug 1898
11
Sophia King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.8.7]
b. 11 Mar 1846 d. 3 Jul 1904
Bailey Charles Miles
b. 9 Nov 1845 d. 28 Sep 1918
12
Nellie Rebecca Miles
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.8.7.1]
b. 21 Jan 1868 d. 22 Oct 1937 [
=>
]
12
Orrin George Miles
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.8.7.2]
b. 17 May 1872 d. 23 Feb 1948 [
=>
]
11
George King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.8.8]
b. 23 Sep 1849 d. 20 May 1851
11
Cortez General King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.8.9]
b. 12 Jun 1851 d. 23 Sep 1894
Katie Belle Schad
b. 5 Jul 1864 d. 31 Dec 1927
12
Clark G King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.8.9.1]
b. 4 Apr 1884 d. 25 Oct 1946
12
Lillian May King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.8.9.2]
b. 27 May 1886 d. 21 Feb 1981 [
=>
]
12
Mabelle G King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.8.9.3]
b. 5 Jul 1888
11
Mary R King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.8.10]
b. 9 Feb 1853 d. 21 Dec 1921
Alfred Daniels
b. 6 Jan 1852 d. 16 Jul 1935
12
Fred Eugene Daniels
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.8.10.1]
b. 7 Apr 1877 d. 1963 [
=>
]
12
Inez Lolia Daniels
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.8.10.2]
b. 2 Dec 1878 [
=>
]
12
Homer Warren Daniels
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.8.10.3]
b. 26 Jun 1880 d. 1971
12
Lula May Daniels
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.8.10.4]
b. 19 Nov 1883 [
=>
]
11
Major S King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.8.11]
b. 4 Mar 1855 d. 11 Nov 1918
11
William Orion King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.8.12]
b. 26 Feb 1857 d. 9 Jun 1930
Saphronia Violet Bean
b. 27 Jun 1874 d. 12 Oct 1944
12
Walter George King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.8.12.1]
b. 3 Nov 1898 d. Sep 1971 [
=>
]
12
Bernice Helen King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.8.12.2]
b. 15 Nov 1901 d. 26 Oct 1982 [
=>
]
12
Veda Violet King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.8.12.3]
b. 1 Feb 1912 d. 18 May 1989 [
=>
]
10
John Noyes King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.9]
b. 17 Dec 1817 d. 5 Feb 1880
Martha Sweet
b. 3 May 1822 d. 19 Jun 1845
11
Mary Janet King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.9.1]
b. 14 Dec 1839 d. 31 Jan 1915
Minor Dennison Bradley
b. 22 Jan 1838 d. 28 Aug 1923
12
Ella Bradley
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.9.1.1]
b. 1863
12
Eddy Bradley
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.9.1.2]
b. 1867
12
Ruby Bradley
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.9.1.3]
b. 1871
12
Sinah Bradley
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.9.1.4]
b. 1879
12
Myrtle M Bradley
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.9.1.5]
b. Sep 1881
11
John Wesley King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.9.2]
b. 1 Nov 1841 d. 1 Sep 1908
Ann Eliza Averill
b. 11 Sep 1844 d. 5 Jun 1931
12
Frederick Oliver King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.9.2.1]
b. 24 Aug 1870 d. 10 Oct 1937 [
=>
]
12
Clara Florence King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.9.2.2]
b. 2 Oct 1871 d. 10 Sep 1948 [
=>
]
12
Son King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.9.2.3]
b. 13 Mar 1874
12
Mattie Edna King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.9.2.4]
b. 25 Aug 1875 d. 1 Mar 1959 [
=>
]
12
Clarence Centennial King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.9.2.5]
b. 8 Dec 1876
12
Mabel Jane King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.9.2.6]
b. 9 Oct 1877
12
Son King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.9.2.7]
b. 6 May 1879
12
Bertha Mary King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.9.2.8]
b. 27 Mar 1880 d. 6 Nov 1969 [
=>
]
12
Maud Sylvia King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.9.2.9]
b. 30 Jan 1884 d. 8 Aug 1969
11
Edward R King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.9.3]
b. 10 Mar 1844 d. 19 Nov 1895
Nancy Adeline Eddy
b. 19 Apr 1828 d. 6 Feb 1901
11
Samuel Monson King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.9.4]
b. 23 Jan 1848 d. 1 Feb 1848
11
George L King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.9.5]
b. 1849
11
Albin Eugene King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.9.6]
b. 25 Jan 1851 d. 14 Jun 1929
Flora de Rose Clanin
b. 12 Apr 1859 d. 14 Nov 1920
12
Annie Lorena King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.9.6.1]
b. 15 Feb 1879 d. 16 Jul 1901
12
Claud W King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.9.6.2]
b. Abt 15 Feb 1882 d. 23 Mar 1886
12
Glenn Racine King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.9.6.3]
b. 2 Mar 1887 d. 18 Nov 1964 [
=>
]
12
Virgil C King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.9.6.4]
b. 1 Apr 1895 d. 26 May 1967
12
Ruth Theresa King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.9.6.5]
b. 17 Feb 1897 d. 8 Jun 1976
12
Blanche Opal King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.9.6.6]
b. 28 Jul 1899 d. Mar 1993
11
Harvey Elwin King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.9.7]
b. 9 Apr 1852 d. 11 Sep 1888
Gula Elmo Bogue
b. 10 Jun 1848 d. 9 Sep 1912
12
William Percy King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.9.7.1]
b. 3 Jul 1876 d. 3 Feb 1961 [
=>
]
12
Ray W King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.9.7.2]
b. 8 Nov 1878
12
Pearl Rosetta King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.9.7.3]
b. 6 Jun 1884 d. 19 Jun 1982 [
=>
]
12
Otis King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.9.7.4]
b. 28 Nov 1886
11
Harriet Agnes King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.9.8]
b. 23 Apr 1855 d. 27 Aug 1922
Franklin M Trumbull
b. 5 Apr 1852 d. 15 Sep 1921
12
Walter Trumbull
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.9.8.1]
b. 5 Jan 1874 d. 6 Feb 1945
12
Nettie Trumbull
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.9.8.2]
b. 13 Jul 1875 d. 10 Apr 1959
12
Cora Trumbull
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.9.8.3]
b. 29 Nov 1876 d. 1961
12
Roy Trumbull
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.9.8.4]
b. 13 Apr 1878 d. 15 Mar 1959
12
Lyman Trumbull
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.9.8.5]
b. 1880 d. 9 Jan 1936
12
Myrtle Eva Trumbull
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.9.8.6]
b. 23 Feb 1882 d. 14 Aug 1958 [
=>
]
12
Vina Trumbull
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.9.8.7]
b. 20 Feb 1884 d. 16 Jul 1934
12
Ralph Trumbull
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.9.8.8]
b. 13 Apr 1886 d. 6 Jul 1952
12
Louie Trumbull
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.9.8.9]
b. 22 May 1889 d. 28 Nov 1948
12
Sidney Trumbull
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.9.8.10]
b. 3 Aug 1891 d. 9 Jul 1957
12
Mabel Trumbull
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.9.8.11]
b. 4 Sep 1893 d. Dec 1968
12
William Trumbull
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.9.8.12]
b. 4 Nov 1896 d. 8 Feb 1953
12
Ruby Trumbull
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.9.8.13]
b. 27 Aug 1899 d. Apr 1975
11
Clara Florence King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.9.9]
b. 21 Apr 1857 d. 21 Dec 1934
George Feron Lewis
b. 21 Feb 1852 d. 10 Nov 1921
12
Henry Benjamin Lewis
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.9.9.1]
b. 10 Sep 1874 d. 29 Aug 1942 [
=>
]
12
Arthur LeRoy Lewis
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.9.9.2]
b. 25 Jan 1876 d. 17 Apr 1960 [
=>
]
12
Lillie Lewis
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.9.9.3]
b. 24 Jul 1879 d. 4 Sep 1957 [
=>
]
12
Vernon Eddy Lewis
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.9.9.4]
b. 19 Sep 1886 d. 24 Aug 1955 [
=>
]
12
Clara Velma Lewis
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.9.9.5]
b. 24 Oct 1898 d. 17 Jan 1974
10
Emmeline King
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.10]
b. 3 Jun 1821 d. 1 Jun 1905
Moses Adams
b. 14 Dec 1814 d. 1893
11
Albert Martin Adams
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.10.1]
b. 10 Apr 1843
+
Maggie Chauvet
11
Charles Wood Adams
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.10.2]
b. 14 May 1847 d. 10 Mar 1930
Lucy Isabelle Bowen
b. 11 Jun 1851 d. 12 Feb 1932
12
Ernest Eugene Adams
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.10.2.1]
b. 11 Jun 1876
12
Albertus Milton Adams
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.10.2.2]
b. 15 Aug 1878
12
Harry Judson Adams
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.10.2.3]
b. 3 Jan 1882
12
Edith Elsie Adams
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.10.2.4]
b. 9 Jun 1890 d. 17 Mar 1950
11
George W Adams
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.10.3]
b. 12 Feb 1851
Rose Reed Smith
12
Roy Elmer Adams
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.10.3.1]
b. 15 Dec 1891 d. 29 Jan 1972 [
=>
]
11
Josephine Adams
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.10.4]
b. 6 Dec 1856
+
Charles W Bowen
11
Eugene Adams
[1.2.3.10.3.1.1.6.4.10.5]
b. 6 Dec 1856 d. 29 Jan 1875
+
Jesse H King
b. 28 Oct 1781 d. 1860
9
Abigail Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.5]
b. 26 May 1783 d. 22 Feb 1835
Jesse H King
b. 28 Oct 1781 d. 1860
10
Aaron Noyes King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1]
b. 31 Jul 1806 d. 6 Jun 1870
Sarah Pierpont Ayres
b. 4 Feb 1807 d. 27 Jul 1845
11
Sarah Mariah King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.1]
b. 21 Mar 1830 d. 2 Apr 1850
11
Henry Hamlin King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.2]
b. 26 Oct 1831 d. 12 Aug 1853
11
Elizabeth Fellows King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.3]
b. 26 Jun 1833 d. 26 May 1847
11
Harriet Jones King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.4]
b. 24 Oct 1834 d. 9 Feb 1896
John D Edmonds
b. Abt 1830 d. 20 Sep 1863
12
Charles Henry Edmonds
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.4.1]
b. 1 Feb 1857
12
George Lawrence Edmonds
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.4.2]
b. 14 Jul 1859
12
Ella Almina Edmonds
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.4.3]
b. 7 Sep 1860
12
Ida May Edmonds
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.4.4]
b. 22 May 1862
Rufus F Johnson
b. 2 Aug 1831 d. Aft 1900
12
Alpha Johnson
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.4.5]
b. 8 Feb 1872
12
Flora Delia Johnson
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.4.6]
b. 30 Sep 1875 d. 18 Mar 1954 [
=>
]
12
William A Johnson
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.4.7]
b. 12 Jul 1876
12
George A Johnson
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.4.8]
b. 1878 d. 1904
11
Jane Eliza Gibson King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.5]
b. 4 Feb 1836 d. 27 Feb 1854
11
Charles Gutsloff King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.6]
b. 20 Jul 1837 d. 23 Dec 1854
11
Mary Ann Ingersol King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.7]
b. 18 Nov 1838 d. 28 Dec 1901
Henry Elliott
12
Carrie Lydia Elliott
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.7.1]
b. 11 Dec 1861 d. 25 Mar 1936
12
Charles Henry Elliott
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.7.2]
b. 30 Nov 1863 d. 17 Nov 1924 [
=>
]
Smith Spencer
b. 28 Aug 1820 d. 11 Sep 1901
12
Lynn King Spencer
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.7.3]
b. 25 May 1875
12
Lyston Spencer
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.7.4]
b. Abt 1877
12
Alice Lillian Spencer
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.7.5]
b. 30 Nov 1877 [
=>
]
11
Abigail Noyes King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.8]
b. 20 Mar 1840 d. 20 Mar 1913
11
Jesse Gustavus King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.9]
b. 13 Jun 1841 d. 28 Feb 1914
Cornelia Van Vlack
b. 19 Jun 1844 d. 23 Jan 1897
12
Harry Vernon King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.9.1]
b. 28 Nov 1867 d. 28 Jul 1954
12
Hollon Richard King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.9.2]
b. 24 Nov 1882 d. 30 Aug 1888
12
Howard Clayton King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.9.3]
b. 1 Sep 1886 d. 17 Dec 1955
12
Clifford Morton King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.9.4]
b. 8 Aug 1888 [
=>
]
11
Alice Amelia King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.10]
b. 16 Mar 1843 d. 5 Jul 1883
William H Kent
b. 1840 d. 1921
12
William Lucias Kent
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.10.1]
b. 11 Nov 1866 d. 23 Sep 1919 [
=>
]
12
William Archie Kent
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.10.2]
b. Abt 1867
11
Albert Kappel King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.11]
b. 2 May 1844 d. 19 Jun 1913
Sarah Ann Clemons
b. 20 Apr 1846 bur. 28 May 1935
12
Merritt Albert King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.11.1]
b. 19 Aug 1871 d. 14 Sep 1934
12
Walter King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.11.2]
b. 1873
12
Frank King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.11.3]
b. 1878
12
Cora May King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.11.4]
b. 21 Jul 1880 d. 7 May 1964 [
=>
]
11
Son King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.12]
b. 1845 d. 1845
Delia Norton
b. 1 Apr 1818 d. 25 Aug 1902
11
Chauncey Lewis King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.13]
b. 27 Nov 1846 d. Bef 1900
Mary Jane Enos
b. 31 May 1846 d. 7 Jul 1900
12
Lettie Lorraine King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.13.1]
b. 25 Jan 1867 d. 27 Jun 1924 [
=>
]
12
Ida May King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.13.2]
b. 18 Feb 1871 d. 18 Oct 1948 [
=>
]
12
Max King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.13.3]
b. Abt 1875
12
Chauncey Horace King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.13.4]
b. 14 Mar 1877 d. 14 Dec 1943
11
LeGrande Morse King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.14]
b. 24 Jan 1848 d. 12 Sep 1918
Sarah Wright
b. 21 Jun 1850 d. 14 Apr 1913
12
Lillian Adelle King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.14.1]
b. 12 Jun 1877 d. 19 May 1961
11
Almira Kent King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.15]
b. 22 Jan 1852 d. 21 Aug 1925
Rufus Sweeting Stolp
b. 11 Apr 1834 d. 1905
12
May Edna Stolp
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.15.1]
b. 3 Oct 1875 [
=>
]
12
Jennie Louise Stolp
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.15.2]
b. 18 Nov 1877 d. 31 Mar 1935 [
=>
]
12
Ray Norton Stolp
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.15.3]
b. 30 Dec 1882 d. 26 May 1958 [
=>
]
11
Emerson Willard King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.16]
b. 26 Apr 1854 d. 16 Nov 1927
Margaret Frances Tripp
b. 30 May 1852 d. 11 Nov 1915
12
Jesse Willard King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.16.1]
b. 18 Apr 1875 d. 21 Jun 1906 [
=>
]
12
Cornelia Elizabeth "Cora" King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.16.2]
b. 27 Dec 1877 d. 11 May 1917 [
=>
]
12
Earl Francis King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.16.3]
b. 10 Nov 1879 d. 4 Dec 1965
12
Albert Kapel King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.16.4]
b. 17 Dec 1881 d. 7 Sep 1964 [
=>
]
12
Emma Louise King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.16.5]
b. 15 Sep 1883 d. 14 Jun 1959 [
=>
]
12
Oliver Grant King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.16.6]
b. 18 Jul 1885 d. 20 Aug 1932 [
=>
]
12
Warren Tripp King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.16.7]
b. 13 Sep 1888 d. 29 Oct 1954 [
=>
]
12
Luella May King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.16.8]
b. 4 Feb 1892 d. 24 Dec 1956
11
Frank Leslie King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.17]
b. 25 Nov 1856 d. 12 Aug 1930
Sara Jane Cassidy
b. 25 Mar 1859 d. 3 Mar 1945
12
Lawrence Norton King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.17.1]
b. 22 Jun 1882 d. 8 Feb 1890
12
Charles Aaron King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.17.2]
b. 25 Mar 1889 d. 2 Nov 1976 [
=>
]
11
Grace Isabelle King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.18]
b. 16 Jul 1861 d. 19 Jul 1943
Francis Joseph De Neveu
b. 5 Jul 1851 d. 1929
12
Edward Gustave De Neveu
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.18.1]
b. 15 Mar 1882 d. 2 Aug 1882
12
Maude Clara De Neveu
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.18.2]
b. 21 Dec 1882 d. 18 Mar 1967 [
=>
]
12
Elmer Rio De Neveu
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.18.3]
b. 23 Mar 1884 d. 30 Sep 1952
12
Virginia Grace De Neveu
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.18.4]
b. 4 Dec 1885 d. 25 Mar 1968
12
Harriett Dousman De Neveu
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.1.18.5]
b. 2 Mar 1887 d. 22 Apr 1963 [
=>
]
10
John Noyes King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.2]
b. 14 Jul 1808
10
Mason Burnard King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.3]
b. 25 Apr 1810 d. 22 Oct 1869
Maritta Albro
b. 13 Apr 1813 d. 3 Sep 1886
11
Nathaniel King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.3.1]
b. 30 Apr 1836 d. 17 Jun 1927
Matilda Jane Gandy
b. 4 Jun 1843 d. 2 Mar 1923
12
Maretta Lucinda King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.3.1.1]
b. 31 Jul 1868 d. 13 Jul 1931 [
=>
]
12
Henry King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.3.1.2]
b. 23 Apr 1873 d. 2 Aug 1885
11
Daniel King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.3.2]
b. Abt 1835
11
Helen King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.3.3]
b. Abt 1838 d. 1931
Merritt G McKoon
b. 1831 d. 2 Oct 1910
12
Menitt P Mckoon
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.3.3.1]
b. 1867
11
Adelbert King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.3.4]
b. Abt 1841
11
David King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.3.5]
b. Abt 1843
11
George King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.3.6]
b. Abt 1845
11
Wesley King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.3.7]
b. Abt 1847
+
Hattie
b. 1850 d. 1927
11
Evelyn Jerucia King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.3.8]
b. 9 Feb 1849 d. 19 May 1916
William Osborn
b. 14 Apr 1842 d. 13 Dec 1900
12
Arthur King Osborn
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.3.8.1]
b. 7 Sep 1872 d. 15 Jul 1957 [
=>
]
12
Jessie Marietta Osborn
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.3.8.2]
b. Feb 1882 d. Jun 1953
12
Raymond Osborn
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.3.8.3]
b. Feb 1892
11
Burnard King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.3.9]
b. Abt 1851
11
Henry King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.3.10]
b. Abt 1853
11
Gilmore King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.3.11]
b. Abt 1855
11
Susan King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.3.12]
b. Abt 1856
10
Lydia King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.4]
b. 11 Apr 1812 d. 2 Feb 1877
Amos Wright
b. 9 Nov 1794 d. 29 Dec 1849
11
James Harvey Wright
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.4.1]
b. 1840 d. Feb 1866
Susie Rachel Mckinney
b. Abt 1842 d. 25 Aug 1866
12
Walter Jerome Wright
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.4.1.1]
b. 4 Oct 1861 d. 21 May 1961 [
=>
]
12
Charles H Wright
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.4.1.2]
b. 24 Jun 1863 d. 8 May 1959
12
Alice Wright
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.4.1.3]
b. 31 Mar 1866 d. 25 Aug 1866
11
Walter Wright
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.4.2]
b. 1844
10
Thomas King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.5]
b. Abt 1814
10
Jesse H King, Jr
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.6]
b. 1815 d. 1 May 1841
10
Cyrus N King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.7]
b. 1817 d. 14 Jun 1833
10
Delia H King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.8]
b. 10 Jan 1820 d. 27 Sep 1884
Lucius E Hubbard
b. 1 May 1816 d. 16 Apr 1880
11
Alice King
[1.2.3.10.3.1.1.6.5.8.1]
b. 1843
9
Betsy Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.6]
b. 5 Jul 1786
+
John Lyons
b. Abt 1782
9
John Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.7]
b. 19 Jul 1789 d. 19 Oct 1856
Abigail Moody
b. 28 Jan 1793 d. 13 Feb 1861
10
Elizabeth M Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.7.1]
b. 21 Dec 1812 d. 23 Dec 1891
John King
b. Abt 1807 d. 21 Sep 1878
11
Lois Cordelia King
[1.2.3.10.3.1.1.6.7.1.1]
b. 12 Jul 1835
John Ballou
b. 12 Aug 1828
12
Milton John Ballou
[1.2.3.10.3.1.1.6.7.1.1.1]
b. 6 Jun 1868 d. 1949 [
=>
]
11
Milton J King
[1.2.3.10.3.1.1.6.7.1.2]
b. 10 May 1839 d. 23 Jun 1867
Etta Watkins
b. 1847
12
Milton John King
[1.2.3.10.3.1.1.6.7.1.2.1]
b. 3 Jun 1867 d. 16 Dec 1949
11
Lura A King
[1.2.3.10.3.1.1.6.7.1.3]
b. 20 Apr 1841 d. 11 Apr 1933
Stillman Amasa Dean
b. 1836 d. 10 Sep 1911
12
Albert Milton Dean
[1.2.3.10.3.1.1.6.7.1.3.1]
b. 5 Dec 1862 d. 1941 [
=>
]
11
Almon L King
[1.2.3.10.3.1.1.6.7.1.4]
b. Abt 1843
11
David C King
[1.2.3.10.3.1.1.6.7.1.5]
b. 10 Mar 1847 d. 4 Apr 1925
Harriet M "Hattie" Dean
b. Abt 1846
12
Alonzo Herman King
[1.2.3.10.3.1.1.6.7.1.5.1]
b. 1 May 1868 d. 12 May 1894 [
=>
]
Susan Ella Knight
b. 1855
12
Paul Dudley King
[1.2.3.10.3.1.1.6.7.1.5.2]
b. 28 May 1891 d. 11 Oct 1975 [
=>
]
11
Aaron B King
[1.2.3.10.3.1.1.6.7.1.6]
b. Abt 1849
10
Mahala Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.7.2]
b. 4 Sep 1815 d. 1 May 1865
10
John Moody Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.7.3]
b. 2 Jun 1817
Elvira Friendly Chandler
b. 23 Nov 1818
11
Orianna Helen "Annie" Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.7.3.1]
b. 16 Jun 1845
+
Herbert P Skofield
b. 1851 d. 1892
11
Eugene H Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.7.3.2]
b. 14 Jul 1847 d. 23 Sep 1848
11
Orville Gould Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.7.3.3]
b. 5 Jul 1863
Estella H Hanscom
b. 1867
12
Maude E Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.7.3.3.1]
b. 4 Jan 1884 [
=>
]
10
Cyrus N Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.7.4]
b. 19 Jul 1819 d. 1897
Almira M Lothrop
b. 1820
11
Idella Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.7.4.1]
b. 1845
11
Mary L Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.7.4.2]
b. 1847
11
Velma Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.7.4.3]
b. 1849
11
Lillienne Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.7.4.4]
b. 1851
10
Joshua W Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.7.5]
b. 20 Jul 1823 d. 6 Jul 1878
Clara Carter
b. 1825
11
Ella Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.7.5.1]
b. 1849
11
Clara Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.7.5.2]
b. 1852
10
Washington M Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.7.6]
b. 11 Feb 1827
Lucy Pool
b. Abt 1827
11
Mary Philinda Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.7.6.1]
b. 6 Oct 1848
11
Ellen E Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.7.6.2]
b. 12 Mar 1851
+
George H Morey
11
Marcellus C Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.7.6.3]
b. 4 Aug 1853
Sarah E Howe
b. 1858
12
Lucy L Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.7.6.3.1]
b. 17 Jun 1881
12
Mary C Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.7.6.3.2]
b. 20 Jun 1890
11
Eugene Hamilton Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.7.6.4]
b. 29 Jan 1856 d. 1 Jun 1915
Nellie Jane Hart
b. 7 Jan 1858
12
Jennie E Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.7.6.4.1]
b. 27 Nov 1882
11
George O Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.7.6.5]
b. 24 Mar 1858
+
Minnie Thomas
+
Emeline Brown
b. 26 Jun 1826 d. 12 May 1880
10
Abigail M Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.7.7]
b. 16 Jun 1835
+
George Ballou
b. 4 Jun 1829 d. 31 Jan 1882
9
Enoch Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.8]
b. 19 Oct 1795 d. 29 Dec 1854
Mary Ann Knox
b. 1798 d. 15 Oct 1859
10
David Knox Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.8.1]
b. 22 Oct 1820 d. 24 Nov 1900
Lucinda Barnes
b. Abt 1827
11
Clara L Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.8.1.1]
b. 26 May 1849
11
David W K Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.8.1.2]
b. 6 May 1851
11
Arthur H Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.8.1.3]
b. 15 Apr 1853
11
Rolla E Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.8.1.4]
b. 18 Jul 1855
Cordelia Draper
b. 1855
12
Royal E Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.8.1.4.1]
b. 11 Aug 1882
12
Arthur H Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.8.1.4.2]
b. 25 Dec 1888
12
John D Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.8.1.4.3]
b. 17 Dec 1890
10
Aaron Alonzo Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.8.2]
b. 22 Nov 1822
Maria Celesta Crandall
b. 25 Apr 1821 d. 11 Jun 1861
11
Emma E Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.8.2.1]
b. 9 May 1852 d. 5 Apr 1853
11
Alice Maud Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.8.2.2]
b. 19 Dec 1853 d. 4 Sep 1892
11
Willis Alonzo Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.8.2.3]
b. 14 May 1855 d. 26 Jan 1875
11
Robert Bruce Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.8.2.4]
b. 25 May 1857 d. 9 Oct 1857
11
Rolla Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.8.2.5]
b. 3 Nov 1860 d. 29 Apr 1861
10
William W Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.8.3]
b. 25 Mar 1825 d. 6 Dec 1855
10
Mary A Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.8.4]
b. 26 Jul 1828
10
Amanda M Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.8.5]
b. 15 Jan 1831 d. 16 Feb 1873
10
Silon Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.8.6]
b. 30 Nov 1832 d. 18 Jan 1875
Maria Thompkins
b. 1835
11
Mary A Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.8.6.1]
b. 1859
11
Alice D Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.8.6.2]
b. Feb 1861
11
Harper S Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.8.6.3]
b. 7 Dec 1868
10
Lydia A Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.8.7]
b. 8 Jul 1834 d. 25 Apr 1891
10
Henry C Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.8.8]
b. 23 Apr 1836
Ann Elizabeth Taylor
b. Abt 1854
11
Clifford Henry Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.8.8.1]
b. 22 Apr 1879
10
Robert B Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.8.9]
b. 9 Mar 1838 d. 5 Feb 1854
9
Cyrus C Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.9]
b. 2 Dec 1797 d. 1859
Louisa Lester
b. 1801
10
William S Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.9.1]
b. 11 Apr 1824
+
Alice A Tallmadge
10
Mortimer Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.9.2]
b. 19 Nov 1845
11
Mortimer Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.9.2.1]
b. 31 Mar 1873
Mary A Jones
b. Abt 1812
10
Mortimer Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.6.9.3]
b. 19 Nov 1854 d. 19 Nov 1872
8
Moses Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.7]
b. 31 Aug 1756 d. 1757
8
Moses Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.8]
b. 23 Oct 1758 d. 4 Aug 1805
+
Sarah Manuel
b. 1755
8
Nathan Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.9]
b. 24 Feb 1761 d. 15 Sep 1825
Sarah Thompson
b. 14 Jun 1760 d. 7 Nov 1832
9
Nathan Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.9.1]
b. 24 May 1782 d. 6 Aug 1856
9
William Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.9.2]
b. 6 Jul 1784 d. 20 Oct 1865
9
James S Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.9.3]
b. 20 Aug 1786 d. 1818
Cynthia Kingsbury
b. 25 May 1794 d. 30 Mar 1873
10
Jason N Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.1]
b. 23 Apr 1819 d. 27 Apr 1894
Mary Taylor
b. 29 Jan 1830 d. 3 Oct 1906
11
Ida Bell Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.1.1]
b. 4 Aug 1853 d. 2 Feb 1935
John Joseph Jefferies
b. 6 Mar 1852 d. 12 Aug 1924
12
May Emogene Jefferies
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.1.1.1]
b. 20 Mar 1874 d. 12 Nov 1933 [
=>
]
12
Ruth Mildred Jefferies
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.1.1.2]
b. 25 Jul 1876 d. 17 Oct 1920 [
=>
]
12
Clara Arminta Jefferies
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.1.1.3]
b. 22 Oct 1878 d. 9 Feb 1943 [
=>
]
12
Jane Estella "Jennie" Jefferies
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.1.1.4]
b. 28 Sep 1880 d. 21 Nov 1959 [
=>
]
12
Mark Joseph Jefferies
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.1.1.5]
b. 6 Mar 1883 d. 23 Dec 1959 [
=>
]
12
Arthur Rodell Jefferies
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.1.1.6]
b. 2 Aug 1885 d. 23 Apr 1967 [
=>
]
12
Ruby Merle Jefferies
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.1.1.7]
b. 16 Jun 1890 d. 10 Apr 1943 [
=>
]
12
Percy Greg Jefferies
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.1.1.8]
b. 25 Jul 1893 d. 27 Apr 1960 [
=>
]
11
Clara Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.1.2]
b. 15 Sep 1854 d. 18 Dec 1920
Warren S Root
b. Apr 1851 d. 22 Apr 1922
12
Hezzy Root
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.1.2.1]
b. 15 Jun 1875 d. 12 Mar 1940
12
Ida M Root
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.1.2.2]
b. 15 Dec 1876 d. 25 Feb 1890
12
Edward Root
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.1.2.3]
b. 11 Dec 1877
12
George Henry Root
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.1.2.4]
b. 1 Mar 1878 d. 29 Nov 1930
12
Vesta Root
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.1.2.5]
b. 4 Feb 1881 d. 18 Sep 1881
12
Winfred James Root
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.1.2.6]
b. 13 Feb 1883 d. 11 Mar 1957
12
Molly Ethel Root
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.1.2.7]
b. 18 Sep 1892 d. 1949
11
Oscar Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.1.3]
b. 13 Dec 1857 d. 2 Jan 1940
Permelia Stelting
b. 28 Sep 1861 d. 26 Feb 1911
12
Murrel Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.1.3.1]
b. 1895
12
Blanche A Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.1.3.2]
b. 23 Oct 1921 d. 5 May 1921
11
Jesse Milo Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.1.4]
b. 28 Apr 1867 d. 15 Jan 1915
Catherine Regina Neibling
b. 28 Aug 1868 d. 7 Jan 1942
12
George Claud Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.1.4.1]
b. 30 Dec 1889 d. 20 Apr 1978 [
=>
]
12
Sylvia Alvina Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.1.4.2]
b. 18 Sep 1891 d. 10 Sep 1970 [
=>
]
12
Fred F Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.1.4.3]
b. 10 Aug 1895 d. 18 Feb 1976
12
Frank Myrel Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.1.4.4]
b. 18 Jan 1893 d. 6 Jan 1977
12
Grace Lorraine Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.1.4.5]
b. 22 Aug 1897 d. 16 Feb 1963 [
=>
]
12
Myrel J Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.1.4.6]
b. 14 Nov 1900 d. Aug 1968 [
=>
]
12
Ruth L Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.1.4.7]
b. 26 Sep 1903 d. 14 May 1971
10
James Solon Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.2]
b. 30 Dec 1821
Cynthia D Know
b. 1825
11
Nellie Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.2.1]
b. 27 Apr 1852
11
Ida M Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.2.2]
b. 12 Nov 1854
11
Lizzie E Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.2.3]
b. 12 Oct 1856 d. 23 Feb 1926
James Martin Rowell
b. 9 Apr 1855 d. 2 Sep 1925
12
Calla Ethel Rowell
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.2.3.1]
b. 8 Nov 1879 d. 29 Apr 1953 [
=>
]
12
Alice Winifred Rowell
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.2.3.2]
b. 9 Sep 1883 d. 1963
12
Ida Madge Rowell
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.2.3.3]
b. 17 Sep 1885 d. 3 Jul 1948
12
Don Noyes Rowell
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.2.3.4]
b. 3 Sep 1890 d. 28 Sep 1918
10
Emily K Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.3]
b. 13 Feb 1824
10
Charles H Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.4]
b. 10 Jan 1826 d. Oct 1911
Lucy Coolidge Hazelton
b. 12 Apr 1833 d. 8 Jul 1921
11
Charles Thomas Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.4.1]
b. 13 Jun 1851 d. Jun 1921
Mary Elizabeth Hussey
b. 16 May 1857 d. 7 Sep 1947
12
Lucy F Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.4.1.1]
b. 3 Feb 1883 d. 6 Oct 1944 [
=>
]
12
George E Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.4.1.2]
b. 9 Sep 1888
11
Harriet Emma Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.4.2]
b. 20 Sep 1853
11
Sidney Marriell Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.4.3]
b. 8 Dec 1854 d. 1864
11
Fred Buzzell Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.4.4]
b. 3 Aug 1857 d. 31 Dec 1946
Julia Ann L Holmes
b. Jan 1862 d. Nov 1914
12
Carrie Ann Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.4.4.1]
b. 15 Apr 1882 [
=>
]
12
Anna L Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.4.4.2]
b. 11 Nov 1883 d. 9 Oct 1952
10
Hezekiah H Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.5]
b. 22 Feb 1828
+
Seraphina Larned Dow
b. 8 Jan 1828 d. 19 Oct 1854
Emily Chandler
b. 1836
11
Horace W Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.5.1]
b. 24 Oct 1857
Jennie M Dwyer
b. 1860
12
James E Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.5.1.1]
b. 11 Mar 1890
11
Charles B Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.5.2]
b. 12 May 1860 d. 9 Aug 1882
11
Nathaniel K Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.5.3]
b. 16 Jan 1865
Ella Kelley Nickerson
b. 4 Mar 1862
12
Edwin M Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.5.3.1]
b. 5 Jan 1892
12
Mabel Kingsbury Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.5.3.2]
b. 14 Apr 1894
12
Richard Storrs Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.5.3.3]
b. 4 May 1898
12
Emily Chandler Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.5.3.4]
b. 25 Jun 1900
11
Mary M Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.5.4]
b. 8 Mar 1875
10
George H Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.6]
b. 30 Apr 1832 d. 12 May 1864
10
Caroline Jane Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.7]
b. 9 Jan 1836 d. 3 Nov 1919
Lemuel Augustus Chandler
b. 26 Jul 1831 d. 5 Nov 1888
11
Carrie Augusta Chandler
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.7.1]
b. 7 Feb 1861 d. 29 Apr 1935
Albert James Gladding
b. 8 Sep 1858 d. 21 Aug 1929
12
Lois Augusta Gladding
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.7.1.1]
b. 3 Aug 1884 d. 23 Jan 1968 [
=>
]
12
Charles Gladding
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.7.1.2]
b. 26 Jun 1887 d. 2 Dec 1959 [
=>
]
12
Augustus Lemuel Gladding
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.7.1.3]
b. 12 Jan 1889 d. 7 Aug 1939 [
=>
]
12
Anita Lucille Gladding
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.7.1.4]
b. 15 Dec 1890 d. 13 Nov 1958
12
Grace Chandler Gladding
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.7.1.5]
b. 12 Dec 1895 d. 19 Sep 1978
12
Albert Chandler Gladding
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.7.1.6]
b. 3 Aug 1897 d. 3 Aug 1964
12
Dorothy Noyes Gladding
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.7.1.7]
b. 19 Aug 1899 d. 23 Feb 1976
12
Doris Bloomfield Gladding
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.7.1.8]
b. 19 Aug 1899 d. 24 Jul 1981
12
Helen Adeline Gladding
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.7.1.9]
b. 1 Feb 1903 d. 26 Oct 1980
12
Caroline Jane Gladding
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.7.1.10]
b. 25 Mar 1905 d. 2 Sep 1971 [
=>
]
11
Wilber Chandler
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.7.2]
b. 30 Jan 1862 d. 17 Nov 1862
11
Annie Louise Chandler
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.7.3]
b. 20 Mar 1863 d. 1 May 1920
Henry Lee Hatch
b. 12 Dec 1861 d. 3 Jan 1926
12
Caroline Chandler Hatch
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.7.3.1]
b. 20 Jun 1890
12
Mildred Ruggles Hatch
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.7.3.2]
b. 3 Sep 1893
12
Henry Curtis Hatch
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.7.3.3]
b. 22 Jan 1894 d. 22 Dec 1956
12
Annie Lee Hatch
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.7.3.4]
b. 11 Sep 1900
11
Hattie G Chandler
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.7.4]
b. 25 May 1864
11
Frank Augustus Chandler
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.7.5]
b. 14 Aug 1865 d. Jul 1872
11
Henry Chandler
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.7.6]
b. 25 Sep 1866 d. 27 Dec 1866
11
Ida May Chandler
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.7.7]
b. 8 May 1869 d. 6 Feb 1935
11
Ernest Chandler
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.7.8]
b. 11 Jun 1870
11
Elizabeth Ella Chandler
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.7.9]
b. 26 Feb 1872 d. 14 Dec 1955
11
Mary Adeline Chandler
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.7.10]
b. 9 Sep 1876 d. 25 Dec 1951
11
Harry Augustus Chandler
[1.2.3.10.3.1.1.9.3.7.11]
b. 26 Dec 1880 d. 31 Dec 1962
+
Adalaide Madeline Richards
b. 1872 d. Sep 1904
+
Ann J Hoyt
b. Abt 1825
9
Amos Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.9.4]
b. 13 Aug 1788 d. 5 Aug 1877
9
Aaron Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.9.5]
b. 30 Sep 1790 d. 21 Oct 1820
Laura K Noyes
b. 14 Jun 1799 d. 11 Dec 1844
10
Aaron G Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.9.5.1]
b. Abt 1824
9
Richard Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.9.6]
b. 30 Mar 1793 d. 15 Aug 1825
9
Samuel Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.9.7]
b. 4 Jul 1795 d. Oct 1867
9
Salley Noyes
[1.2.3.10.3.1.1.9.8]
b. 21 Nov 1798
7
Benjamin Noyes
[1.2.3.10.3.1.2]
b. 20 Dec 1721 d. 27 Aug 1748
Sarah Pickard
b. 18 May 1723 d. 25 Aug 1748
8
Sarah Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.1]
b. 14 Mar 1745 d. 12 Feb 1824
George Jewett
b. 18 Mar 1747 d. 5 May 1829
9
Sarah Jewett
[1.2.3.10.3.1.2.1.1]
b. 11 Jan 1772
9
Susannah Jewett
[1.2.3.10.3.1.2.1.2]
b. 5 Jun 1773
9
Hannah Jewett
[1.2.3.10.3.1.2.1.3]
b. 25 Oct 1774
9
Lucy Jewett
[1.2.3.10.3.1.2.1.4]
b. 2 Aug 1776
9
Dolly Jewett
[1.2.3.10.3.1.2.1.5]
b. 26 Jun 1779
8
Johnathan Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2]
b. 9 Feb 1746 d. 8 Aug 1831
Elizabeth Platt
b. 1748
9
Benjamin Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.1]
b. 30 Sep 1766 d. Jan 1859
Lois Turner
b. 1770 d. 28 Jan 1830
10
Abiel Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.1.1]
b. 13 Jan 1792
10
Susanna Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.1.2]
b. 8 Jan 1796
10
Lois Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.1.3]
b. 18 Apr 1800
10
Joseph Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.1.4]
b. 16 Mar 1804
9
Jonathan Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.2]
b. 10 Jun 1768 d. 1845
9
Moses Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3]
b. 14 Feb 1770 d. 5 Mar 1846
Sarah Currier
b. 29 Jul 1770 d. 17 Aug 1848
10
Daniel Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.1]
b. 25 Jan 1797 d. 11 Mar 1864
Susannah Cooper
b. 2 Jun 1797 d. 10 Oct 1878
11
Isaiah Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.1.1]
b. 21 Oct 1816 d. 11 Sep 1898
Martha Cooper
b. 10 Nov 1825
12
Alvesta V Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.1.1.1]
b. 12 Jul 1845
12
Louisa Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.1.1.2]
b. 10 Sep 1847 [
=>
]
12
Charles Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.1.1.3]
b. 8 Jan 1850
12
Augustus Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.1.1.4]
b. 1 Jul 1852
12
Miles Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.1.1.5]
b. 28 Sep 1855
Patience Nolan
b. 1838
12
Everett L Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.1.1.6]
b. 4 Dec 1859 d. 26 Dec 1930
12
Albert J Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.1.1.7]
b. 8 Jun 1866 [
=>
]
12
Chester L Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.1.1.8]
b. 20 Nov 1872
11
Ephraim Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.1.2]
b. 1818 d. 1889
Mary Ann Plummer
b. Abt 1823
12
Sarah B Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.1.2.1]
b. 5 Jul 1845
12
Hattie A Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.1.2.2]
b. 3 Apr 1847 d. 1875
12
Vesta L Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.1.2.3]
b. 25 Oct 1848
12
John E Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.1.2.4]
b. 18 May 1850 d. 27 Jun 1888
11
Lydia Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.1.3]
b. Jul 1820
David Dunton
b. Abt 1814 d. Bef 1870
12
Marcellus Dunton
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.1.3.1]
b. 28 Oct 1841 d. 22 Jan 1844
12
Malora Dunton
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.1.3.2]
b. 30 Jul 1843 [
=>
]
12
Marcellus W Dunton
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.1.3.3]
b. 13 Oct 1845 [
=>
]
12
Lydia J Dunton
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.1.3.4]
b. Abt 1848
12
Corena Dunton
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.1.3.5]
b. Abt 1852 [
=>
]
12
Abby Dunton
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.1.3.6]
b. Abt 1856
12
Oraville L Dunton
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.1.3.7]
b. Nov 1859 [
=>
]
12
Belle M Dunton
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.1.3.8]
b. Abt 1864
11
Nathaniel Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.1.4]
b. 9 Jul 1822 d. 26 Oct 1905
Louisa Cooper
b. 26 Feb 1828 d. 22 Mar 1879
12
Rockland Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.1.4.1]
b. 1854 d. 1916
12
Eva A Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.1.4.2]
b. 1 Nov 1859 d. 7 Apr 1894
12
Ruel J Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.1.4.3]
b. Jan 1862 [
=>
]
+
Nancy E Parlin
b. Dec 1847
11
Sarah Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.1.5]
b. 1825 d. 1886
11
Moses Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.1.6]
b. 1827 d. 1865
11
Charles Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.1.7]
b. 1830 d. 1901
+
Adaline Spencer
11
Susan Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.1.8]
b. 1831 d. 1861
11
Hannah Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.1.9]
b. 1832
11
Eliza Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.1.10]
b. 1834
11
Albert Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.1.11]
b. 1838 d. 1865
+
Ellen Conley
11
Margaret Augusta Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.1.12]
b. 25 Dec 1839 d. 4 Dec 1932
Elbridge Jacob Reed
b. 25 Sep 1837 d. 19 Jun 1880
12
Almar Noyes Reed
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.1.12.1]
b. 1 Apr 1865 d. 2 Jun 1926 [
=>
]
12
Theron Delmar Reed
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.1.12.2]
b. 19 Nov 1869 d. 29 Jan 1962
+
Frank Ebenezer Baker
b. 17 May 1841 d. 13 Jan 1925
11
Daniel Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.1.13]
b. 1842
+
Mary E Chenney
10
Lydia Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.2]
b. 11 Mar 1798
+
Rufus Rowe
b. 15 May 1796 d. 15 May 1865
10
Martha Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.3]
b. 25 Sep 1800 d. 17 Aug 1848
James Rowe
b. 20 Feb 1791 d. 14 Apr 1857
11
Hiram Rowe
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.3.1]
b. Abt 1819
11
Levi Rowe
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.3.2]
b. 1822 d. 22 Aug 1851
Hannah
b. 1827 d. 22 Aug 1851
12
John P Rowe
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.3.2.1]
b. 1847
12
Martha H Rowe
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.3.2.2]
b. 18 Nov 1850 d. 16 Oct 1875
11
Uriah Taylor Rowe
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.3.3]
b. 28 Jun 1824 d. 8 Oct 1890
Esther Warner Robinson
b. 7 Feb 1826 d. 25 Jun 1891
12
Alvesta Mary Rowe
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.3.3.1]
b. 13 Aug 1848 d. 7 Sep 1916 [
=>
]
12
Martha H Rowe
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.3.3.2]
b. 1850
12
Alonzo Moses Rowe
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.3.3.3]
b. 9 Apr 1852 d. 13 Jun 1899 [
=>
]
12
Ida Melissa Rowe
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.3.3.4]
b. 9 Nov 1858 d. 8 May 1927 [
=>
]
12
Frank Ellsworth Rowe
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.3.3.5]
b. 7 Jun 1864 d. 27 Apr 1918 [
=>
]
12
Herbert Augustus Jennings Rowe
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.3.3.6]
b. 25 Nov 1867 d. 5 May 1910 [
=>
]
11
Hannah N Rowe
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.3.4]
b. 26 Jul 1827
11
James Noyes Rowe
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.3.5]
b. Abt 1829
11
Lydia Margaret Rowe
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.3.6]
b. 16 Aug 1832 d. 18 Feb 1860
Lorenzo D Robinson
b. 1828
12
Altha A Robinson
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.3.6.1]
b. 1 Mar 1855 d. 10 Feb 1932 [
=>
]
11
Ann Caroline Rowe
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.3.7]
b. 26 Sep 1834 d. 17 May 1854
11
Daniel R Rowe
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.3.8]
b. 27 Sep 1837 d. Jul 1863
11
Melissa Jane Rowe
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.3.9]
b. 20 Dec 1840
11
Albert Eli Rowe
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.3.10]
b. 25 Jun 1843
10
Frances "Fanny" Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.4]
b. 28 Jul 1802 d. 15 Feb 1884
Peter Philbrick
b. 26 Mar 1798 d. 9 May 1871
11
Susan N Philbrick
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.4.1]
b. 13 Dec 1822 d. 14 Jul 1885
+
William Henry Abbott
b. 13 Jan 1822 d. 13 Feb 1876
11
Mehitable B Philbrick
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.4.2]
b. 15 Jan 1827 d. 18 Dec 1893
+
John J Corbit
b. 8 Mar 1832 d. 1 Sep 1912
11
George W P Philbrick
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.4.3]
b. 10 Dec 1828 d. 15 Apr 1913
Lydia Ann Noyes
b. 29 Mar 1833 bur. 23 Sep 1909
12
Philman Anson Philbrick
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.4.3.1]
b. 22 Jan 1855 d. 24 Nov 1930 [
=>
]
12
Cora Emma Philbrick
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.4.3.2]
b. 1857 d. 2 Apr 1914 [
=>
]
12
Marcellus Philbrick
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.4.3.3]
b. Abt 1859 d. 17 Mar 1860
12
Freddie Philbrick
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.4.3.4]
b. Oct 1863 d. 15 Apr 1868
12
Peter Philbrick
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.4.3.5]
b. Abt 1866 d. 9 Apr 1868
12
George Allen Philbrick
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.4.3.6]
b. 25 Jan 1869 d. 14 Jan 1936 [
=>
]
12
Frank Philbrick
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.4.3.7]
b. Abt 1871 d. 27 Mar 1872
12
Walter Philbrick
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.4.3.8]
b. Jun 1873 d. 10 Dec 1958
12
Della I Philbrick
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.4.3.9]
b. 1877 d. 13 Mar 1884
11
Sarah Annie Philbrick
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.4.4]
b. 6 Nov 1830 d. 13 Dec 1906
+
Willard Snell Kimball
11
Sylvia H Philbrick
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.4.5]
b. 4 Aug 1832 d. 15 Dec 1865
John S Southerland
b. 1825 d. 16 Oct 1863
12
Walter John Sutherland
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.4.5.1]
b. 14 Jun 1860 d. 20 May 1906 [
=>
]
11
Rachel M Philbrick
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.4.6]
b. 23 Apr 1834
+
George Roberts
11
Rhadamanthus Philbrick
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.4.7]
b. 8 Sep 1836 d. 14 Nov 1925
11
Frances G Philbrick
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.4.8]
b. 7 Apr 1840 d. 19 Apr 1882
Cyrus S Noyes
b. 26 May 1839 d. 8 Sep 1916
12
Lizzie M Noyes .
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.4.8.1]
b. 28 Feb 1860
12
Abbie F Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.4.8.2]
b. 7 Feb 1863
12
Leslie C Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.4.8.3]
b. 11 Jun 1866
11
Caroline Evangeline Philbrick
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.4.9]
b. 30 May 1843 d. 2 Jun 1919
William H Bowden
b. 1831 d. 21 Jun 1877
12
Charles Colyear Bowden
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.4.9.1]
b. 1 Jun 1868 d. 15 Oct 1941
12
John W Bowden
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.4.9.2]
b. 8 Feb 1870 d. 27 Nov 1923 [
=>
]
12
William H Bowden
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.4.9.3]
b. 24 Mar 1871 d. 14 Apr 1928
12
Della Bowden
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.4.9.4]
b. 25 Mar 1873 d. 24 Jan 1926
12
Belle Caroline Bowden
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.4.9.5]
b. 7 Feb 1876 d. 17 Dec 1957
11
Lizzie B Philbrick
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.4.10]
b. 18 Jul 1845 d. 9 Oct 1909
James F Mckee
b. Nov 1848
12
Emma Mckee
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.4.10.1]
b. May 1874
11
Mary C Philbrick
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.4.11]
b. 18 Jul 1845 d. 3 Mar 1886
+
Joseph H Low
11
Chandler Noyes Philbrick
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.4.12]
b. 21 Jun 1824 d. 14 May 1866
Elmira W Caine
b. 1822 d. 1856
12
Elroy Prescott Philbrick
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.4.12.1]
b. Apr 1849 d. 9 Jan 1914 [
=>
]
Janna Christina Veldboom
b. 29 Oct 1839 d. 25 May 1906
12
Ola Sylvia Philbrick
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.4.12.2]
b. 28 Jul 1857 d. 25 Jul 1932 [
=>
]
12
Lee J Philbrick
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.4.12.3]
b. 22 Jul 1859 d. 6 Feb 1942 [
=>
]
12
Ray Philbrick
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.4.12.4]
b. 1864
12
Ada C Philbrick
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.4.12.5]
b. 1865
12
Chandler N Philbrick
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.4.12.6]
b. 20 Mar 1866 d. 21 Jan 1952 [
=>
]
10
Susanna Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.5]
b. 4 Jun 1804
10
Hezekiah Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.6]
b. 1 Sep 1807 d. 30 May 1846
Mary W Walker
b. Abt 1810
11
Abram W Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.6.1]
b. 12 Jul 1831 d. 15 Oct 1894
Sarah J Kenney
b. 1833 d. 1872
12
Henry W Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.6.1.1]
b. 12 Apr 1854 d. 6 Dec 1871
12
Charles F Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.6.1.2]
b. 29 Aug 1855 [
=>
]
12
Martin L Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.6.1.3]
b. 15 Feb 1858 [
=>
]
12
Mary J Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.6.1.4]
b. 13 Jan 1859 d. 21 May 1877
11
James Abram Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.6.2]
b. 27 Sep 1837
Ruth Ann Glidden
b. 12 Apr 1838 d. 19 Jun 1873
12
Ruth Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.6.2.1]
b. 10 Jun 1859
12
Daniel Harrison Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.6.2.2]
b. 11 Nov 1864 [
=>
]
12
Lambert A Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.6.2.3]
b. 22 Oct 1866 [
=>
]
12
Ruth M Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.6.2.4]
b. 4 Apr 1872
11
Lydia Ann Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.6.3]
b. 29 Mar 1833 bur. 23 Sep 1909
George W P Philbrick
b. 10 Dec 1828 d. 15 Apr 1913
12
Philman Anson Philbrick
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.6.3.1]
b. 22 Jan 1855 d. 24 Nov 1930 [
=>
]
12
Cora Emma Philbrick
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.6.3.2]
b. 1857 d. 2 Apr 1914 [
=>
]
12
Marcellus Philbrick
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.6.3.3]
b. Abt 1859 d. 17 Mar 1860
12
Freddie Philbrick
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.6.3.4]
b. Oct 1863 d. 15 Apr 1868
12
Peter Philbrick
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.6.3.5]
b. Abt 1866 d. 9 Apr 1868
12
George Allen Philbrick
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.6.3.6]
b. 25 Jan 1869 d. 14 Jan 1936 [
=>
]
12
Frank Philbrick
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.6.3.7]
b. Abt 1871 d. 27 Mar 1872
12
Walter Philbrick
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.6.3.8]
b. Jun 1873 d. 10 Dec 1958
12
Della I Philbrick
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.6.3.9]
b. 1877 d. 13 Mar 1884
11
Eli Pierce Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.6.4]
b. 12 Jul 1835 d. 11 Jul 1884
Marcia Cummings Spalding
b. 21 Feb 1835
12
Anna Marcia Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.6.4.1]
b. 5 Apr 1866
12
Willie E Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.6.4.2]
b. 1 Feb 1869
11
Danvill Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.6.5]
b. 3 Jul 1840
Adeline M Dunton
b. 13 Feb 1842 d. 17 Aug 1922
12
George A Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.6.5.1]
b. 16 Feb 1864
12
William C Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.6.5.2]
b. 28 May 1868 d. 1909 [
=>
]
12
Danville Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.6.5.3]
b. 11 Sep 1870
12
Mary A Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.6.5.4]
b. 24 Sep 1877 d. 11 Sep 1896
11
Alvanus Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.6.6]
b. 27 Dec 1842 d. 1895
Sarah E Hodgkin
b. 1846
12
Son Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.6.6.1]
b. 1865 d. 1865
11
Hezekiah Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.6.7]
b. 17 Jul 1846
Abbie J Pooler
b. 1850
12
Fred P Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.6.7.1]
b. 11 Jul 1870
10
Chandler Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.7]
b. 20 Aug 1810 d. 1878
Abigail Perkins
b. Abt 1815
11
Martha Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.7.1]
b. Abt 1837
11
Eli Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.7.2]
b. Abt 1838 d. 1864
11
Cyrus S Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.7.3]
b. 26 May 1839 d. 8 Sep 1916
Frances G Philbrick
b. 7 Apr 1840 d. 19 Apr 1882
12
Lizzie M Noyes .
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.7.3.1]
b. 28 Feb 1860
12
Abbie F Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.7.3.2]
b. 7 Feb 1863
12
Leslie C Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.7.3.3]
b. 11 Jun 1866
11
Hubbard Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.7.4]
b. Abt 1841
11
Mary Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.7.5]
b. Abt 1843
11
Henry Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.7.6]
b. Abt 1845
10
Eli Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.8]
b. 27 Apr 1814 d. 10 Sep 1854
Clementina Pierce
b. 1817 d. 1901
11
Columbia P Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.8.1]
b. 1836 d. 6 Jun 1890
Parker W Dresser
b. 2 Apr 1825 d. 28 Mar 1901
12
Clarence Parker Dresser
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.8.1.1]
b. Abt 1862 [
=>
]
12
Lily Belle Dresser
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.8.1.2]
b. Abt 1864 [
=>
]
12
Mary Eugenia Dresser
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.8.1.3]
b. Abt 1866
12
Fannie Noyes Dresser
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.8.1.4]
b. Abt 1872 d. 1945 [
=>
]
12
Alice Winifred Dresser
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.8.1.5]
b. Abt 1870
11
Eusebeus H Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.8.2]
b. 28 Nov 1846 d. 24 May 1893
Attie Wright
b. 25 Dec 1856 d. 1 Jun 1935
12
Harvey Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.8.2.1]
b. 1878
12
Charles Wright Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.8.2.2]
b. 2 Aug 1879
12
Fanny Elizabeth Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.8.2.3]
b. 2 Jul 1880 d. 13 Nov 1963 [
=>
]
11
Luther Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.8.3]
b. 1849
10
Isaiah Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.9]
b. 20 Nov 1816
10
Hannah Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.3.10]
+
Jeremiah Rowe
b. 25 Jun 1799
9
Nathaniel Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.4]
b. 16 Dec 1771 d. 26 Nov 1854
Annie Currier
b. Abt 1773
10
Mary Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.4.1]
b. 7 Jan 1799 d. 2 Jul 1866
+
Ezekial Potter
10
Abram Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.4.2]
b. 3 Mar 1803 d. 1877
Polly Decker
b. Abt 1805
11
William P Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.4.2.1]
b. 28 Jul 1834
Emma W Tucker
b. 1835
12
Heman A Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.4.2.1.1]
b. 17 Jun 1861
12
Grace S Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.4.2.1.2]
b. 17 May 1863
12
Lulu E Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.4.2.1.3]
b. 4 Nov 1875
11
Hannah Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.4.2.2]
b. 27 Feb 1838
11
Albert D Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.4.2.3]
b. 11 Jun 1840 d. 20 Nov 1876
11
Son Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.4.2.4]
b. 1842
10
Sarah Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.4.3]
b. Sep 1806 d. 1827
10
Son Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.4.4]
b. 1808
10
Son Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.4.5]
b. 1810
9
Sally Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.5]
b. 9 Jun 1772 d. 1 Jul 1831
Samuel Little
b. 2 Sep 1772 d. 20 Dec 1849
10
Susan Little
[1.2.3.10.3.1.2.2.5.1]
b. 10 Nov 1800 d. 9 Feb 1871
+
John G Savage
b. Abt 1796
10
John Little
[1.2.3.10.3.1.2.2.5.2]
b. 27 Jun 1802 d. 16 Jun 1877
10
Moses Little
[1.2.3.10.3.1.2.2.5.3]
b. 6 May 1803 d. 9 Apr 1829
10
David Little
[1.2.3.10.3.1.2.2.5.4]
b. 11 Nov 1804 d. 29 Sep 1827
10
Eli Little
[1.2.3.10.3.1.2.2.5.5]
b. 5 Jun 1806 d. 17 Feb 1887
Mary Bailey
b. 5 Jun 1815
11
Elizabeth Little
[1.2.3.10.3.1.2.2.5.5.1]
b. 29 Jul 1830
11
Evalina Jewett Little
[1.2.3.10.3.1.2.2.5.5.2]
b. 17 Feb 1841 d. 30 Aug 1917
Ruel H Seekins
b. 1 May 1839
12
William Everett Seekins
[1.2.3.10.3.1.2.2.5.5.2.1]
b. 5 Sep 1858 d. 13 Aug 1945
12
Eddie E Seekins
[1.2.3.10.3.1.2.2.5.5.2.2]
b. 16 Oct 1860 d. 16 Jan 1952
12
Herbert L Seekins
[1.2.3.10.3.1.2.2.5.5.2.3]
b. 21 Nov 1863
Bradford H Reed
b. 11 Feb 1836 d. 2 Feb 1909
12
Elbert Guy Reed
[1.2.3.10.3.1.2.2.5.5.2.4]
b. 19 Apr 1881 d. 6 May 1952 [
=>
]
11
Sarah Tamson Little
[1.2.3.10.3.1.2.2.5.5.3]
b. 5 Nov 1838
John Linscott
12
Ozelvin John Linscott
[1.2.3.10.3.1.2.2.5.5.3.1]
b. 29 Jun 1856
11
Mary Luetta Little
[1.2.3.10.3.1.2.2.5.5.4]
b. 16 Sep 1843 d. 11 Jun 1916
George Edward Kent Moody
b. 26 Jun 1840 d. 4 Apr 1914
12
George A Moody
[1.2.3.10.3.1.2.2.5.5.4.1]
b. 2 Feb 1862 d. 14 Oct 1913 [
=>
]
12
Arthur B Moody
[1.2.3.10.3.1.2.2.5.5.4.2]
b. 26 Jun 1873 [
=>
]
11
Julia Ann Little
[1.2.3.10.3.1.2.2.5.5.5]
b. 1 Jun 1846
+
Miles Lovell Avery
b. Abt 1842
11
Eli Laureston Little
[1.2.3.10.3.1.2.2.5.5.6]
b. 6 Mar 1850
11
Ella Elizabeth Little
[1.2.3.10.3.1.2.2.5.5.7]
b. 16 Jul 1852
+
Ruel Balcom
b. Abt 1848
11
Moses Franklin Little
[1.2.3.10.3.1.2.2.5.5.8]
b. 6 Feb 1855
Belle F Cheney
b. Abt 1859
12
Euela Little
[1.2.3.10.3.1.2.2.5.5.8.1]
b. 15 Jan 1890
11
Laura Jane Little
[1.2.3.10.3.1.2.2.5.5.9]
b. 29 May 1858 d. 18 Apr 1863
10
Sarah Little
[1.2.3.10.3.1.2.2.5.6]
b. 5 Jun 1809 d. 11 Mar 1831
10
Samuel Little
[1.2.3.10.3.1.2.2.5.7]
b. 3 Jun 1811 d. Abt 1895
Hannah J Boynton
b. 7 May 1813 d. 1900
11
Melissa A Little
[1.2.3.10.3.1.2.2.5.7.1]
b. 1849 d. 1936
11
Xenophan John Little
[1.2.3.10.3.1.2.2.5.7.2]
+
Isabel A McDonald
10
Mary Ann Little
[1.2.3.10.3.1.2.2.5.8]
b. 18 Feb 1813 d. 2 Aug 1876
Thomas Boynton
b. 1 Nov 1812 d. 26 Feb 1903
11
Rebecca A Boynton
[1.2.3.10.3.1.2.2.5.8.1]
b. 1841 d. 3 Nov 1877
11
Cyrus E Boynton
[1.2.3.10.3.1.2.2.5.8.2]
b. 1843 d. 1927
11
Oscar Wilson Boynton
[1.2.3.10.3.1.2.2.5.8.3]
b. 22 May 1845 d. 21 Apr 1924
11
Eli L Boynton
[1.2.3.10.3.1.2.2.5.8.4]
b. 12 Aug 1847 d. 14 May 1941
11
Elen M Boynton
[1.2.3.10.3.1.2.2.5.8.5]
b. 1850
11
Alpheus Boynton
[1.2.3.10.3.1.2.2.5.8.6]
b. 1853
10
Julia Little
[1.2.3.10.3.1.2.2.5.9]
b. 14 Jan 1815 d. 12 Feb 1819
10
Hannah Sylvester Little
[1.2.3.10.3.1.2.2.5.10]
b. 26 Jul 1816 d. Abt 1857
9
Lydia Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.6]
b. Abt 1773
+
Abijah Little
9
John Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.7]
b. 22 Apr 1782
Margaret Lash
b. 28 Nov 1785 d. 25 Mar 1840
10
Hiram Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.7.1]
b. 8 Aug 1807
+
Josephine Jones
b. 1810
10
Rachel Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.7.2]
b. 22 Oct 1809
10
Aaron Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.7.3]
b. 10 Jul 1812
10
Paul Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.7.4]
b. 1 Jun 1814
10
Margaret Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.7.5]
b. 17 Nov 1816 d. 5 May 1856
Cowell Hatch
b. 29 Jul 1814 d. 30 Jan 1858
11
Edwin Hatch
[1.2.3.10.3.1.2.2.7.5.1]
b. 19 Oct 1840 d. 30 Aug 1842
11
Ann Eliza Hatch
[1.2.3.10.3.1.2.2.7.5.2]
b. 6 Feb 1842 d. 28 Aug 1902
Wilmot G Shattuck
b. 24 Apr 1836 d. 1911
12
Marsha Shattuck
[1.2.3.10.3.1.2.2.7.5.2.1]
b. 1867
12
George Shattuck
[1.2.3.10.3.1.2.2.7.5.2.2]
b. 1871
12
Maggie Shattuck
[1.2.3.10.3.1.2.2.7.5.2.3]
b. 1876
12
Joseph Boardman Shattuck
[1.2.3.10.3.1.2.2.7.5.2.4]
b. 18 May 1877 d. 1958 [
=>
]
12
Clara Belle Shattuck
[1.2.3.10.3.1.2.2.7.5.2.5]
b. 9 Oct 1878 d. 27 Mar 1939 [
=>
]
11
Caroline Hatch
[1.2.3.10.3.1.2.2.7.5.3]
b. 5 Nov 1843 d. 4 Feb 1844
11
Aldana Hatch
[1.2.3.10.3.1.2.2.7.5.4]
b. 28 Nov 1844 d. 12 Oct 1861
11
Henry J Hatch
[1.2.3.10.3.1.2.2.7.5.5]
b. 16 Dec 1855 d. 4 Jul 1907
10
Abiel Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.7.6]
b. 3 Sep 1819
10
Eliza Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.7.7]
b. 27 Jan 1821
10
Balinda Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.7.8]
b. 5 Jan 1824
10
John Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.7.9]
b. 23 Apr 1826
9
Isaac Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.8]
b. 1787 d. 1845
Hannah Plummer
b. Abt 1790
10
Albert Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.8.1]
b. 27 Apr 1812
+
Margaret Johnson
10
Son Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.8.2]
b. 1814
10
Son Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.8.3]
b. 1816
10
Son Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.8.4]
b. 1818
9
Daniel Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.9]
b. Abt 1788
Mary Bradbury
b. Abt 1792
10
Lois C Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.9.1]
b. Abt 1802
+
Samuel Cockson
10
Silas Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.9.2]
b. Abt 1802
+
Hannah Shepard
9
Aaron Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.10]
b. 10 Jul 1789 d. 5 Jan 1867
Nancy Bradbury
b. Abt 1800
10
Hannah Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.10.1]
b. 1829
10
Maria L Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.10.2]
b. 6 Jun 1832 d. 16 Jun 1898
10
Lydia E Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.10.3]
b. 22 Jul 1834 d. Sep 1862
10
Aaron B Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.10.4]
b. 6 Feb 1837
Ina H Bond
b. Abt 1839
11
Clyde S Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.10.4.1]
b. Apr 1869
11
Walter D Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.10.4.2]
b. May 1872
9
Enoch Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.2.11]
b. Abt 1791
+
Hapsibah G Heath
8
Son Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.3]
b. 1748 d. 1748
8
Son Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.4]
b. 1750 d. 1750
8
Son Noyes
[1.2.3.10.3.1.2.5]
b. 1752 d. 1752
5
Nicholas Noyes
[1.2.3.10.4]
b. 22 Dec 1647 d. 13 Dec 1717
+
Elizabeth Dunster
b. Abt 1630 bur. 30 Dec 1715
5
Deacon Cutting Noyes
[1.2.3.10.5]
b. 23 Sep 1649 d. 25 Oct 1734
5
James Noyes
[1.2.3.10.6]
b. 16 May 1657 d. Aft 22 Apr 1723
4
John Noyes
[1.2.3.11]
c. 27 Mar 1617 d. Aft 24 Jul 1660
Elizabeth Bulpit
b. Abt 1622
5
Simon Noyes
[1.2.3.11.1]
c. 19 Feb 1641
5
Mary Noyes
[1.2.3.11.2]
c. 10 May 1643
5
Bridgat Noyes
[1.2.3.11.3]
c. 4 Dec 1656
3
Marie Parker
[1.2.4]
b. 1577
3
Cuthbert Parker
[1.2.5]
b. 1577 d. 8 Jul 1636
3
Edward Parker
[1.2.6]
b. 1581 d. Aft 1631
3
William Parker
[1.2.7]
b. Abt 1591
2
Thomas Parker
[1.3]
b. 1 Jan 1559 d. 3 Mar 1634
2
Rogerus Parker
[1.4]
b. 1561 d. 29 Aug 1629
2
William Parker
[1.5]
b. 23 Mar 1561 d. 25 May 1631
2
Jane Parker
[1.6]
c. 10 Oct 1568