Home Page
|
What's New
|
Photos
|
Histories
|
Headstones
|
Reports
|
Surnames
Search
First Name:
Last Name:
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Suomalainen
Svenska
Margery
1507 -
Submit Photo / Document
Individual
Descendants
Relationship
Timeline
Submit Photo / Doc
Worksheet
Family
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Margery
[1]
b. 1507
John Turner
b. Abt 1531
2
Grace Turner
[1.1]
b. 1555 d. 5 Jun 1612
John Field
b. Abt 1535 d. 24 Nov 1615
3
Abiah Field
[1.1.1]
b. 21 May 1577
+
Elkanah Nashe
3
Martha Field
[1.1.2]
b. 16 Feb 1579 d. 24 Oct 1663
Thomas Deacon
b. 1570 d. 24 Oct 1663
4
Phebe Deacon
[1.1.2.1]
b. 3 Apr 1597 d. 20 Sep 1663
Zaccheus Gould
b. 1 Oct 1589 d. 30 Mar 1668
5
Phebe Gould
[1.1.2.1.1]
b. 27 Sep 1620 d. 7 May 1686
Thomas Perkins
b. 28 Apr 1622 d. 7 May 1686
6
John Perkins
[1.1.2.1.1.1]
b. Abt 1641 d. 19 May 1688
Deborah Browning
c. 31 Jan 1646 d. Aft 1704
7
Thomas Perkins
[1.1.2.1.1.1.1]
b. 4 May 1667 d. 3 Jun 1709
6
Phebe Perkins
[1.1.2.1.1.2]
b. 1644 d. 1680
Jacob Towne
c. 11 Mar 1632 d. 20 Feb 1713
7
Phebe Towne
[1.1.2.1.1.2.1]
b. 4 May 1666 d. 3 Jan 1669
7
Joanna Towne
[1.1.2.1.1.2.2]
b. 22 Jan 1668 d. 1736
+
Thomas Nichols
b. 20 Jan 1670 d. Aft 1725
7
Mary Towne
[1.1.2.1.1.2.3]
b. 27 Mar 1670 d. Aft 1695
+
Isaac Larrabee
b. 1663 d. May 1755
7
Susanna Towne
[1.1.2.1.1.2.4]
b. 24 Dec 1671 d. 13 Sep 1766
John Cummings
b. 7 Jun 1666 d. 3 Jul 1706
8
Joseph Cummings
[1.1.2.1.1.2.4.1]
b. Jan 1689 d. 22 Apr 1794
8
Sarah Cummings
[1.1.2.1.1.2.4.2]
b. 30 May 1690 d. Aft 1728
8
John Cummings
[1.1.2.1.1.2.4.3]
b. 12 Jun 1692
8
Isaac Cummings
[1.1.2.1.1.2.4.4]
b. 25 Dec 1695 d. Abt 1752
8
David Cummings
[1.1.2.1.1.2.4.5]
b. 15 Apr 1698 d. 2 Apr 1765
8
Mary Cummings
[1.1.2.1.1.2.4.6]
b. 13 May 1700 d. Bef 1732
8
Susannah Cummings
[1.1.2.1.1.2.4.7]
b. 13 Jan 1702 d. 1723
8
Hannah Cummings
[1.1.2.1.1.2.4.8]
c. 21 Dec 1718 d. 1718
7
Joseph Towne
[1.1.2.1.1.2.5]
b. 22 Mar 1673 d. 28 May 1757
7
Sarah Towne
[1.1.2.1.1.2.6]
b. 30 Dec 1675 d. 1 Nov 1760
7
John Towne
[1.1.2.1.1.2.7]
b. 20 Feb 1678 d. 28 Mar 1714
Abigail Stanley
b. 6 Aug 1688 d. 1 Sep 1743
8
John Towne
[1.1.2.1.1.2.7.1]
b. 5 Dec 1729 d. 9 Jan 1820
8
Abigail Towne
[1.1.2.1.1.2.7.2]
b. 29 Sep 1721 d. 8 Dec 1739
8
Catherine Towne
[1.1.2.1.1.2.7.3]
b. 14 Dec 1725
8
Bartholemew Towne
[1.1.2.1.1.2.7.4]
b. 4 Apr 1713 d. 9 May 1783
8
Samuel Towne
[1.1.2.1.1.2.7.5]
b. 1717 d. Nov 1778
8
Johnathan Towne
[1.1.2.1.1.2.7.6]
b. 5 Dec 1729 bur. Jul 1771
7
Martha Towne
[1.1.2.1.1.2.8]
b. 19 May 1680 d. 24 Feb 1753
+
Isaac Leach
b. Abt 1676
7
Phebe Towne
[1.1.2.1.1.2.9]
b. 23 Jul 1685 d. 10 Jun 1736
John Gould
b. 25 Aug 1687 d. 20 Jul 1762
8
John Gould
[1.1.2.1.1.2.9.1]
b. 9 Apr 1712 d. 18 Apr 1712
8
Kezia Gould
[1.1.2.1.1.2.9.2]
b. 10 May 1718 d. 28 Dec 1798
8
Stephen Gould
[1.1.2.1.1.2.9.3]
b. 6 Jul 1724 d. 1798
8
Ruth Gould
[1.1.2.1.1.2.9.4]
b. 16 Sep 1727 d. Not Needed
8
Esther Gould
[1.1.2.1.1.2.9.5]
b. 10 Aug 1732 d. 1785
6
Zaccheus Perkins
[1.1.2.1.1.3]
b. 1647 d. 1 Dec 1732
6
Thomas Perkins
[1.1.2.1.1.4]
b. Abt 1648 d. Apr 1722
Sarah Wallis
b. 24 Jul 1658 d. 1719
7
Thomas Perkins
[1.1.2.1.1.4.1]
b. 9 Dec 1688
7
Hannah Perkins
[1.1.2.1.1.4.2]
b. 1690 d. 1 Jan 1747
7
Robert Perkins
[1.1.2.1.1.4.3]
b. Abt 1695 d. 15 Jan 1750
7
Samuel Perkins
[1.1.2.1.1.4.4]
b. 18 May 1712 d. 1 Jan 1747
6
Martha Perkins
[1.1.2.1.1.5]
b. 1649 d. Abt 1728
John Lamson
b. Nov 1642 d. Bef 23 Jun 1717
7
John Lamson, Jr
[1.1.2.1.1.5.1]
b. 21 Nov 1669 d. 1 Sep 1760
7
Phebe Lamson
[1.1.2.1.1.5.2]
b. 13 Aug 1673 d. 23 May 1753
7
William Lamson
[1.1.2.1.1.5.3]
b. 19 Aug 1675 d. 1750
7
Martha Lamson
[1.1.2.1.1.5.4]
b. 21 Aug 1677 d. Abt 1724
7
Thomas Lamson
[1.1.2.1.1.5.5]
b. 3 Jan 1682 d. Jul 1767
7
Samuel Lamson
[1.1.2.1.1.5.6]
b. 25 Feb 1684 d. 17 Nov 1760
6
Mary Perkins
[1.1.2.1.1.6]
b. 1651 d. 1728
William Howlet
b. Abt 1650 d. 1718
7
John Howlet
[1.1.2.1.1.6.1]
b. Abt 1676 d. 7 Sep 1735
6
Judith Perkins
[1.1.2.1.1.7]
b. 11 Jul 1655 d. Abt 1743
Nathaniel Browne
b. 1645 bur. 13 Sep 1717
7
Nathaniel Brown
[1.1.2.1.1.7.1]
b. Abt 1676 d. Abt 12 Feb 1759
7
Elizabeth Brown
[1.1.2.1.1.7.2]
b. Abt 1678 d. Bef 1716
6
Elisha Perkins
[1.1.2.1.1.8]
b. 1656 d. 18 Feb 1741
Catharine Towne
b. 25 Feb 1662 d. 2 Jul 1714
7
Thomas Perkins
[1.1.2.1.1.8.1]
b. 15 Oct 1681 d. 1761
7
Elisha Perkins
[1.1.2.1.1.8.2]
b. 27 May 1683 d. 24 Dec 1704
7
John Perkins
[1.1.2.1.1.8.3]
b. 12 Aug 1685 d. 22 Jun 1750
7
Catharina Perkins
[1.1.2.1.1.8.4]
c. 3 Feb 1687
7
Phebe Perkins
[1.1.2.1.1.8.5]
b. 10 Aug 1690
7
Jacob B Perkins
[1.1.2.1.1.8.6]
c. 13 Nov 1692 d. 18 Nov 1758
7
Ruth Perkins
[1.1.2.1.1.8.7]
c. 10 May 1695 d. 9 Jun 1695
7
Mary Perkins
[1.1.2.1.1.8.8]
b. 30 Mar 1699 d. 1737
7
Joseph Perkins
[1.1.2.1.1.8.9]
b. 10 May 1702 d. 1777
6
Timothy Perkins
[1.1.2.1.1.9]
b. 6 Jun 1661 d. 18 Dec 1751
5
Mary Gould
[1.1.2.1.2]
b. 12 Dec 1621 d. 15 Nov 1690
John Reddington
b. Abt 1617 d. 15 Nov 1690
6
Daniel Reddingtion
[1.1.2.1.2.1]
b. 1645 d. 28 Sep 1732
6
Eliza Reddington
[1.1.2.1.2.2]
b. 1648
6
John Reddington
[1.1.2.1.2.3]
b. 20 Jun 1649 d. 8 Mar 1650
6
Mary Reddington
[1.1.2.1.2.4]
b. 4 May 1651 d. 13 Mar 1682
6
Phebe Reddington
[1.1.2.1.2.5]
b. 7 Apr 1655 d. 1 Oct 1696
6
Martha Reddington
[1.1.2.1.2.6]
b. 7 Apr 1655 d. 7 Aug 1731
6
Sarah Reddington
[1.1.2.1.2.7]
c. 12 Mar 1658 d. 8 Jul 1689
5
Martha Gould
[1.1.2.1.3]
b. 19 Jun 1623 d. Abt 1699
John Newmarch
b. 1619 d. 7 Mar 1696
6
John Newmarch
[1.1.2.1.3.1]
b. Abt 1649 d. 21 May 1733
6
Thomas Newmarch
[1.1.2.1.3.2]
b. Abt 1651 d. 9 Jul 1716
6
Sara Newmarch
[1.1.2.1.3.3]
b. Abt 1652 d. 1751
6
Phebe Newmarch
[1.1.2.1.3.4]
b. Abt 1652
6
Martha Newmarch
[1.1.2.1.3.5]
b. Abt 1652 d. 7 Jul 1720
6
Zaccheus Neumarch
[1.1.2.1.3.6]
b. Abt 1653 d. 1731
5
Priscilla Gould
[1.1.2.1.4]
b. 27 Sep 1628 d. 16 Sep 1663
John Wildes
b. 1620 d. 14 May 1705
6
Sarah Wildes
[1.1.2.1.4.1]
b. 1647 d. 12 May 1711
6
Elizabeth Wildes
[1.1.2.1.4.2]
b. 1653 d. 25 Jun 1718
Lieutenant Benjamin Jones
b. 31 Jul 1651 d. 25 Jun 1718
7
Lieutenant Thomas Jones
[1.1.2.1.4.2.1]
b. 13 Mar 1680 d. 4 Nov 1763
Mary Meacham
b. 12 Jan 1684 d. 8 Nov 1744
8
Mary Jones
[1.1.2.1.4.2.1.1]
b. 22 Apr 1709 d. 4 Nov 1780
Abraham Whipple
b. Abt 1709 d. 3 Oct 1768
9
Bathsheba Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.1]
b. 2 Feb 1731
9
Abraham Whipple, Jr
[1.1.2.1.4.2.1.1.2]
b. 18 Mar 1734
9
Mary Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.3]
b. 1 Mar 1735 d. 6 Dec 1823
9
Samuel Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.4]
b. 7 Jan 1737 d. 28 Sep 1762
+
Oliver Evans
b. Abt 1741
9
Joseph Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.5]
b. 18 May 1740
Abigail Gary
b. 2 Jul 1743
10
Abraham Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.5.1]
b. 11 Feb 1768 d. 12 Jan 1852
9
Luther Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6]
b. 7 Mar 1743 d. 1830
Eunice Gates
b. Abt 1744
10
Abram Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.1]
b. 11 Feb 1768 d. 12 Jan 1852
Asenath Sumner
b. 2 Aug 1768 d. 23 Dec 1851
11
Abigail Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.1.1]
b. 1794 d. 13 Apr 1870
Isaac Coon
b. 25 Apr 1792 d. 5 Jan 1878
12
Lucinda Coon
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.1.1.1]
b. 1815 d. 7 Apr 1881
11
Louisa Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.1.2]
b. 1798 d. 12 Apr 1889
11
Eunice Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.1.3]
b. 1800
11
Daniel Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.1.4]
b. 20 Nov 1801 d. 26 Apr 1889
Maria Chamberlain
b. 9 Aug 1825 d. 31 Dec 1891
12
Jane Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.1.4.1]
b. 14 Nov 1850 d. 19 Jul 1932
12
Jerome Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.1.4.2]
b. 17 Mar 1853 d. 17 Nov 1921
12
Abraham Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.1.4.3]
b. May 1863
12
Elizabeth Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.1.4.4]
b. 1866 d. 1937
12
Sarah Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.1.4.5]
b. 23 Feb 1869 d. 24 Apr 1895
11
Asenath "Sena" Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.1.5]
b. 1803 d. 27 May 1896
Lyman Hoyt
b. 1804
12
Lucy Ann Hoyt
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.1.5.1]
b. Abt 1834 d. 26 Feb 1920 [
=>
]
12
Mary Hoyt
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.1.5.2]
b. Abt 1836
12
Sarah Hoyt
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.1.5.3]
b. Abt 1838
12
Lois Hoyt
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.1.5.4]
b. Abt 1844 d. Bef 1860
12
Esther Hoyt
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.1.5.5]
b. Abt 1846
12
Henry V Hoyt
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.1.5.6]
b. 27 Feb 1850 d. 10 Sep 1933
11
Lydia Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.1.6]
b. 1806 d. 19 Sep 1880
Jacob Mead
b. 3 Aug 1807 d. 14 Oct 1880
12
Aseneth Mead
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.1.6.1]
b. 17 Dec 1831 d. 29 Apr 1844
11
Henry Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.1.7]
b. 22 May 1807 d. 13 Jan 1895
Polly Ellis
b. 22 Mar 1816
12
Harrison Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.1.7.1]
b. 1835
12
Gardner C Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.1.7.2]
b. 12 Aug 1849 d. 25 Sep 1926
12
Betsey Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.1.7.3]
b. 1850
12
Caroline Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.1.7.4]
b. 1851
12
Adelbert Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.1.7.5]
b. Oct 1854 d. 1936
12
Warren Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.1.7.6]
b. Aug 1863 d. 25 Apr 1915
11
George "Leo" Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.1.8]
b. 18 May 1809 d. 19 Jul 1896
Sarah Maritta Stratter
b. 9 Jan 1811 d. 31 Aug 1889
12
Mary E Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.1.8.1]
b. Feb 1838 d. 11 Feb 1917 [
=>
]
12
Jonathan S Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.1.8.2]
b. 1840 d. 1933
12
Judson A Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.1.8.3]
b. 9 Jul 1847 d. 25 Jan 1931 [
=>
]
12
Daniel Burdette Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.1.8.4]
b. 1853 d. 1922
11
Abraham Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.1.9]
b. 1810 d. Abt 1888
Catherine Smith
b. Oct 1819 d. Aft 1900
12
Isaac Conrad Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.1.9.1]
b. 4 Mar 1838 d. 24 May 1927 [
=>
]
12
Agnes Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.1.9.2]
b. May 1839 d. 1930
12
Catherine Minerva Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.1.9.3]
b. 1840 [
=>
]
12
Alena Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.1.9.4]
b. 1841
12
Julia Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.1.9.5]
b. 1843
12
Richard Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.1.9.6]
b. 1845 [
=>
]
12
Abraham Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.1.9.7]
b. 1847
12
Lavinda Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.1.9.8]
b. 1853 d. 10 Oct 1878
12
Ida Jane Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.1.9.9]
b. Abt 1858
12
George B Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.1.9.10]
b. Abt 1862
12
Abby Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.1.9.11]
b. Abt 1874
11
Caroline Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.1.10]
b. 1811
11
Jane Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.1.11]
b. 1812 d. 3 Aug 1872
10
Eunice Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.2]
b. 18 Mar 1770 d. 26 Feb 1863
10
Polly Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.3]
b. 1772 d. 24 Aug 1847
Thomas Whittlesey
b. 28 Feb 1772 d. 2 Mar 1847
11
Lucy Whittlesey
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.3.1]
b. Jun 1797 d. Jul 1865
11
Maria Whittlesey
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.3.2]
b. 9 Apr 1805
11
Eliza Whittlesey
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.3.3]
b. 19 Aug 1807 d. Abt 1831
George Peck
b. 1810
12
Nancy Maria Peck
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.3.3.1]
b. 30 May 1833 d. 8 Jul 1911 [
=>
]
11
Thomas Jefferson Whittlesey
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.3.4]
b. 13 Jun 1812
11
Isaac Whittlesey
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.3.5]
b. 25 Mar 1815
Adelaide Shailor
b. 13 Sep 1819 d. 18 Feb 1856
12
Josephine Ann Whittlesey
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.3.5.1]
b. 28 Apr 1847 d. 2 Mar 1850
12
Charles Chester Whittlesey
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.3.5.2]
b. 28 Nov 1851
12
Adelaide Maria Whittlesey
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.3.5.3]
b. 28 Jan 1855
11
Francis Elmira Whittlesey
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.3.6]
b. 30 Sep 1817
10
Elizabeth Gates Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.4]
b. 19 Aug 1775 d. 26 Jun 1862
John Sawyer
b. 10 May 1773 d. 21 Apr 1871
11
Abraham Sawyer
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.4.1]
b. 1 Feb 1796 d. 9 Apr 1868
11
John Sawyer
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.4.2]
b. 14 Apr 1805 d. 26 Feb 1880
Elizabeth Quick
b. 15 May 1807 d. 1901
12
Lewis Sawyer
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.4.2.1]
b. 23 Aug 1825
12
Hiram Sawyer
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.4.2.2]
b. 26 Jun 1826 d. 14 Mar 1913
12
Sarah A Sawyer
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.4.2.3]
b. 24 Sep 1837 d. 30 Nov 1918 [
=>
]
11
Issac Sawyer
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.4.3]
b. 3 Sep 1816 d. 1 Jul 1912
11
Ira Sawyer
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.4.4]
b. 3 Sep 1816 d. 28 Nov 1899
Damaris Burrows
b. 4 Oct 1828 d. 29 Mar 1929
12
Franklin W Sawyer
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.4.4.1]
b. 20 Apr 1855 d. 14 Aug 1941
12
Jasper Sawyer
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.4.4.2]
b. 1857 d. Bef 1870
12
John L Sawyer
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.4.4.3]
b. Oct 1858 d. 25 Jan 1915 [
=>
]
12
Luther D Sawyer
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.4.4.4]
b. 1860 [
=>
]
12
Sarah Sawyer
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.4.4.5]
b. Abt Jun 1862 [
=>
]
12
Vina Sawyer
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.4.4.6]
b. 1864
12
Frederick W Sawyer
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.4.4.7]
b. 1865
12
Tim Sawyer
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.4.4.8]
b. 1867
12
Simeon F Sawyer
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.4.4.9]
b. 1868
12
Andrew J Sawyer
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.4.4.10]
b. 1869 d. 7 Oct 1935
12
Nancy J Sawyer
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.4.4.11]
b. 1871
12
Jennie Sawyer
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.4.4.12]
b. 1872
12
Jasper Sawyer
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.4.4.13]
b. 1874
10
Lydia Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.5]
b. 1777
10
Martha Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.6]
b. 1781
10
Clarissa Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.7]
b. 11 Mar 1784
Joel Sawyer, Jr
b. 7 Aug 1781 d. 1 Sep 1859
11
Joel W Sawyer
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.7.1]
b. 6 Dec 1815 d. 25 Dec 1908
+
Sarah Ann Moore
b. Abt 1818
+
Saphronie Simmons
b. Abt 1819
10
Henry Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.8]
b. Abt 1785 d. Aft 1800
10
Thomas Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.9]
b. 1787 d. 18 Sep 1887
Cynthia Allen
b. 3 Feb 1788 d. 30 Oct 1861
11
Allen G Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.9.1]
b. 1812 d. Aft 8 Jun 1880
Lydia Cranston
b. 1801 d. 1879
12
Sarah Malvinia Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.9.1.1]
b. 1837 [
=>
]
12
Samuel C Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.9.1.2]
b. 1840
11
Thomas Corbin Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.9.2]
b. 28 Mar 1814 d. 9 Feb 1892
Maria Winner
b. 18 Mar 1811 d. 24 Aug 1891
12
John H Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.9.2.1]
b. 18 Feb 1841 d. Jun 1917
11
Ruth Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.9.3]
b. Abt 1816
11
Abigail Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.9.4]
b. Abt 1818
11
Ira Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.6.9.5]
b. 2 Jan 1820 d. 7 Oct 1895
9
Anna Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.7]
b. 17 Feb 1744 d. 1811
Robert Follett
b. 27 Apr 1739 d. 9 Apr 1810
10
Robert Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.1]
b. 15 Sep 1764
Molly Knap
b. 17 Apr 1766
11
Nancy Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.1.1]
b. Aft 1800
10
Anna Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.2]
b. 22 Mar 1766 d. 23 Apr 1839
Joseph Ford
b. 29 Feb 1768 d. 30 Jan 1846
11
Sarah Ford
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.2.1]
b. 1793 d. 1842
Nathan Neal
b. 1790
12
Mary Neal
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.2.1.1]
b. 1813
12
Joseph Neal
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.2.1.2]
b. 1814
12
Anna Neal
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.2.1.3]
b. 13 May 1816 [
=>
]
12
Perley Neal
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.2.1.4]
b. 1817
12
Fannie Neal
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.2.1.5]
b. 1818
12
Orrin S Neal
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.2.1.6]
b. 4 Nov 1819 d. 17 Jan 1903 [
=>
]
12
George Neal
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.2.1.7]
b. 1822
12
Sally Neal
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.2.1.8]
b. 1825
11
John Perley Ford
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.2.2]
b. 6 Dec 1794 d. 18 Sep 1869
Susanna Catharine Gallman
b. 10 Jul 1803 d. 1862
12
George Washington Ford
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.1]
b. Abt 1813 d. 2 Jan 1913 [
=>
]
12
Joseph Perley Ford
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.2]
b. 25 Jun 1826 d. 1855 [
=>
]
12
Jesse Stanley Ford
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.3]
b. 1828 [
=>
]
12
John Gallman Ford
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.4]
b. 9 Sep 1829 d. 1 Jan 1883 [
=>
]
12
Sarah Ann Ford
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.5]
b. 10 May 1831 d. 28 Nov 1920 [
=>
]
12
Susan K Ford
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.6]
b. 25 Oct 1835 d. 22 Oct 1836
12
Thomas Cellars Ford
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.7]
b. 1 Aug 1838 d. 7 Sep 1921 [
=>
]
12
David Daly Ford
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.8]
b. 18 Nov 1840 d. 17 Jan 1923 [
=>
]
12
William Follett Ford
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.2.2.9]
b. 28 Feb 1843 d. 28 Aug 1862
11
Anna Ford
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.2.3]
b. 1796
11
Mary Ophria Ford
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.2.4]
b. 1798
11
Joseph Ford
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.2.5]
b. 12 May 1800 d. 26 Sep 1882
Olive Lindsay
b. 17 Dec 1806 d. 4 Oct 1881
12
Electa Ford
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.2.5.1]
b. Abt 1827 d. 15 Jun 1854 [
=>
]
12
Orville Davencourt Ford
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.2.5.2]
b. 28 Aug 1829 d. 9 May 1909 [
=>
]
12
Ortan Davencourt Ford
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.2.5.3]
b. 19 Mar 1833 d. 14 Jan 1908 [
=>
]
12
Devillo C Ford
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.2.5.4]
b. 2 Apr 1835 d. 1 May 1862
12
Annette I Ford
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.2.5.5]
b. 1838
12
Adelia Minerva Ford
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.2.5.6]
b. 21 May 1843 d. 4 Apr 1927 [
=>
]
12
Achsah Amelia Ford
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.2.5.7]
b. 29 May 1846 d. 26 Jun 1924 [
=>
]
11
Chloe Ford
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.2.6]
b. 1803
Francis L Drake
b. Abt 1800
12
Mayville Deforest Drake
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.2.6.1]
b. 1839 d. 1910 [
=>
]
10
Mary Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.3]
b. 10 Oct 1767 d. Bef 1810
10
Abigail Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.4]
b. 18 Feb 1770
John Delong
b. Abt 1768
11
Eunice Delong
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.4.1]
b. 2 Dec 1796 d. 20 Feb 1884
10
Calvin Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.5]
b. 6 Jan 1772 d. 21 Dec 1856
Drusilla Kempton
b. Abt 1787 d. 8 Apr 1856
11
William Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.5.1]
b. 18 Dec 1801
+
Fanny Pierce
b. 7 Jan 1803
11
Benjamin Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.5.2]
b. 22 Oct 1803 d. 11 Dec 1892
Hannah M Warren
b. 16 Jan 1813 d. 18 Jun 1900
12
Edwin Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.5.2.1]
b. Abt 1829
12
N Ellen Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.5.2.2]
b. Abt 1830
12
Hannah Ellen Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.5.2.3]
b. 3 Feb 1830
11
Ephraim Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.5.3]
b. 24 Dec 1805 d. 1 May 1864
Diana Higgins
b. 18 Mar 1806 d. 30 May 1886
12
Ephraim E Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.5.3.1]
b. 1835 d. 23 Nov 1911 [
=>
]
12
Edward Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.5.3.2]
b. Abt 1836
12
Willard Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.5.3.3]
b. 1838 d. 1 Dec 1917
12
Oliver Stowell Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.5.3.4]
b. Abt 1849
12
Emily Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.5.3.5]
b. 26 Mar 1863 [
=>
]
12
William Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.5.3.6]
b. 16 Aug 1841
11
Calvin Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.5.4]
b. 1807
Samantha
b. 1823
12
Ellen Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.5.4.1]
b. Abt 1850
12
Eugene W Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.5.4.2]
b. Oct 1851 d. 6 Apr 1906 [
=>
]
12
Edwin B Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.5.4.3]
b. Jan 1855 [
=>
]
11
Anna Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.5.5]
b. 1809 d. 24 Aug 1832
11
Daughter Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.5.6]
b. 1810
11
Daughter Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.5.7]
b. 1813
11
Hiram Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.5.8]
b. 1 Nov 1816 d. 20 Jan 1892
Emily Ames
b. 10 Jul 1818 d. 14 Oct 1885
12
Maria Louisa Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.5.8.1]
b. 8 Feb 1847 d. 17 Nov 1866
12
Anna A Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.5.8.2]
b. 18 May 1849 d. 15 Apr 1936 [
=>
]
12
Edgar Ames Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.5.8.3]
b. 19 Dec 1857 d. 24 Jul 1924
11
Louisa Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.5.9]
b. 1819
11
Calvin Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.5.10]
b. 1822
11
Mary Jane Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.5.11]
b. 1825
Isaac Maldron
b. Abt 1821
12
Saprillet Maldron
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.5.11.1]
b. Abt 1851
12
Falconer Maldron
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.5.11.2]
b. Abt 1854
12
Purley Maldron
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.5.11.3]
b. Abt 1856
12
Hanley Maldron
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.5.11.4]
b. Abt 1858
11
Fanny Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.5.12]
b. 1831 d. 11 Mar 1832
10
Elijah Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.6]
b. 29 Mar 1775 d. Jul 1816
Sabra Hill
b. 28 Apr 1779 d. 24 Apr 1842
11
John Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.6.1]
b. Abt 1799
+
Paulina
b. Abt 1813
11
Sarah "Sally" Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.6.2]
b. Abt 1803
Henry Robinson
b. 1800 d. Aug 1874
12
Thomas W Robinson
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.6.2.1]
b. 1830
12
George H Robinson
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.6.2.2]
b. 1834
12
James M Robinson
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.6.2.3]
b. Abt 1836 [
=>
]
12
Mary Elizabeth Robinson
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.6.2.4]
b. 1843 d. 1913 [
=>
]
11
Samuel Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.6.3]
b. 26 Dec 1803 d. 1885
Marinda Rockwell
b. 1804 d. 5 Mar 1867
12
Erastus Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.1]
b. 18 Mar 1827 d. 22 Mar 1886 [
=>
]
12
David M Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.2]
b. 1828 d. 29 Nov 1889 [
=>
]
12
Marchel Abraham Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.3]
b. 2 May 1830 d. 30 Jul 1907 [
=>
]
12
John D Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.4]
b. 1832 d. 1900 [
=>
]
12
Harlow Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.5]
b. 15 Aug 1834 d. 2 Jul 1911 [
=>
]
12
Orville Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.6]
b. Abt 1834
12
Mary Jane Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.7]
b. 1839 d. 21 Apr 1862
12
Samuel Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.8]
b. 12 Apr 1840 d. 7 Apr 1917 [
=>
]
12
Mary Ann Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.9]
b. Abt 1841
12
Orren Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.10]
b. Feb 1842 d. 26 Jul 1907
12
George W Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.11]
b. 29 Mar 1845 d. 9 Jul 1926 [
=>
]
12
Willard Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.6.3.12]
b. 27 Jul 1847 d. 14 Sep 1916 [
=>
]
11
Orpha Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.6.4]
b. Abt 1805
+
John Harrington
b. 9 Jun 1803
11
Daniel Edward Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.6.5]
b. 11 Nov 1807 d. 27 Nov 1901
Catherine Jane Longyear
b. 27 Apr 1814 d. 15 Jun 1886
12
Emmerson Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.6.5.1]
b. Sep 1835 [
=>
]
12
Mary Jane Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.6.5.2]
b. 12 Feb 1837 d. 15 Jan 1915 [
=>
]
12
Daughter Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.6.5.3]
b. 1839
12
Calvin Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.6.5.4]
b. Nov 1843 [
=>
]
12
Sarah Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.6.5.5]
b. 1844
12
James Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.6.5.6]
b. 1845
12
Daniel Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.6.5.7]
b. 1846
12
Charles Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.6.5.8]
b. 1849
12
Frances Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.6.5.9]
b. 1851
12
Lurancy Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.6.5.10]
b. Abt 1852 [
=>
]
11
Eunice Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.6.6]
b. Abt 1809
+
John Harrington
11
Ann Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.6.7]
b. Abt 1811
+
John Orr
11
Elsie Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.6.8]
b. 1811
11
Joseph Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.6.9]
b. 17 Jun 1814 d. 1897
Cynthia Stiles
b. 3 Jan 1823 d. 2 Jun 1900
12
John D Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.6.9.1]
b. 30 Sep 1845 d. 5 Oct 1846
12
Sabra Ann Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.6.9.2]
b. 15 Sep 1847 d. 18 Sep 1908 [
=>
]
12
Cornelia Jane Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.6.9.3]
b. 25 Apr 1849 d. 12 Jul 1901 [
=>
]
12
Joseph Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.6.9.4]
b. 29 Aug 1850 d. 4 Oct 1909
12
Sarah Louisa Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.6.9.5]
b. 27 Oct 1851 d. 29 Mar 1863
12
Gerome M Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.6.9.6]
b. 24 Jul 1855 d. 18 May 1858
12
Henry Francis Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.6.9.7]
b. 12 May 1859 d. Nov 1927
12
Mary Elizabeth Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.6.9.8]
b. 29 Aug 1861 d. 27 Dec 1862
10
Samuel Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.7]
b. 2 Apr 1776
Rebecca
b. Abt 1778
11
Permelia Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.7.1]
b. Abt 1817
10
William Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.8]
b. 3 Mar 1778 d. 1853
Sybil Blackman
b. 1780 d. Bef 1850
11
Betsy Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.8.1]
b. 1808
11
Ann Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.8.2]
b. 1810
11
John Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.8.3]
b. 1813
Hannah
b. Abt 1815
12
Martin Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.8.3.1]
b. Bef 1850
11
William Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.8.4]
b. 1820
Hannah
b. Abt 1825
12
Frances E Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.8.4.1]
b. Abt 1857 d. 20 Oct 1899
11
Hannah Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.8.5]
b. 21 Feb 1824 d. 21 Oct 1898
11
Samuel B Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.8.6]
b. 6 Nov 1827 d. 13 Feb 1920
Almeda White
12
Charles S Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.8.6.1]
b. 4 Mar 1856 d. 20 Jan 1863
12
Edward W Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.8.6.2]
b. 23 Sep 1865 d. 26 Mar 1928
+
Esther Osborn
b. 1 Apr 1842 d. 21 Oct 1895
11
Henry Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.8.7]
b. 15 Oct 1829 d. 31 May 1905
10
Eunice Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.9]
b. 28 Mar 1779
Joseph Baker
b. Abt 1777
11
Joseph Baker, Jr
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.9.1]
b. Abt 1799
11
John Baker
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.9.2]
b. Abt 1801
11
Erastus Baker
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.9.3]
b. Abt 1803
+
Loraney Mann
11
Norma Baker
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.9.4]
b. Abt 1805
11
Maria Baker
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.9.5]
b. 1809
John B Van Dyke
b. 9 Oct 1808 d. 30 Jul 1883
12
Richard W Van Dyke
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.9.5.1]
b. 28 Feb 1836 d. 28 Mar 1864
12
John Van Dyke
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.9.5.2]
b. 6 Jan 1839
10
John Follett
[1.1.2.1.4.2.1.1.7.10]
b. 22 Aug 1783
+
Lydia Reed
b. 1785
9
Calvin Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.8]
b. 17 Aug 1745 d. 10 Nov 1762
9
Deborah Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.9]
b. 6 Aug 1747
9
Daniel Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10]
b. 7 Sep 1749 d. 1798
Deborah Hildreth
b. 5 May 1755 d. Abt 1789
10
Samuel Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.1]
b. 1777 d. Aft 1800
10
Daniel Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2]
b. 27 Aug 1779 d. 27 Sep 1839
Mary Tiffany
b. 17 Jun 1777 d. 12 Sep 1845
11
Cynthia Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.1]
b. 15 Jan 1805 d. 1889
Ezra Gray
b. 1793 d. 1870
12
Hiram T Gray
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.1.1]
b. 25 Aug 1832 d. 30 Jun 1875
12
Daniel William Gray
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.1.2]
b. 19 May 1834 d. 9 Dec 1890 [
=>
]
12
Daughter Gray
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.1.3]
b. 1834
12
Emily Jane Gray
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.1.4]
b. 14 Nov 1837 d. 13 Feb 1908
12
Betsey T Gray
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.1.5]
b. 1840
12
Mary M Gray
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.1.6]
b. 1844
12
George W Gray
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.1.7]
b. 1846 d. 4 Aug 1918 [
=>
]
11
Samuel Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.2]
b. 21 Dec 1808 d. 9 Jan 1887
Phoebe Kingsbury
b. 14 Dec 1812 d. 24 Apr 1851
12
Sabrina Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.2.1]
b. 30 Mar 1832 d. 1920
12
George T Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.2.2]
b. 4 Dec 1833 d. 28 Aug 1868
12
Polly Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.2.3]
b. 4 Jun 1835 d. 24 Mar 1855
12
Daniel Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.2.4]
b. 21 Jun 1837
12
Margaret Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.2.5]
b. 18 Jun 1839 d. 8 Oct 1840
12
Mason Kingsbury Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.2.6]
b. 17 Feb 1842 d. 27 Mar 1919 [
=>
]
12
Samuel Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.2.7]
b. 4 Mar 1844 d. May 1924
12
Hassett Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.2.8]
b. 20 Feb 1846 d. 3 Jan 1852
12
Almira Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.2.9]
b. 21 Apr 1848 d. 22 Sep 1911
12
Cynthia Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.2.10]
b. 10 Nov 1850 d. 17 Apr 1851
11
Almira Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.3]
b. 13 Jun 1810 d. 4 Feb 1889
George Tiffany
b. 4 May 1808 d. 21 Jun 1885
12
Cynthia Jane Tiffany
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.1]
b. 2 Feb 1830 d. 6 Oct 1845
12
Zenos Tiffany
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.2]
b. 21 Jul 1831 d. Dec 1843
12
Ira Patchen Tiffany
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.3]
b. 14 Feb 1835 d. 21 Mar 1905 [
=>
]
12
Loyal Peck Tiffany
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.4]
b. 27 Jul 1837 d. 15 Feb 1903
12
Mary Tiffany
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.5]
b. 18 Dec 1844 d. 14 Dec 1845
12
Almira Rebecca Tiffany
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.6]
b. 18 Aug 1847 d. 23 Nov 1914 [
=>
]
12
George Mason Tiffany
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.7]
b. 31 Jan 1850 d. 14 Mar 1909 [
=>
]
12
Nelson Whipple Tiffany
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.3.8]
b. 6 Aug 1852 d. 20 Jan 1927 [
=>
]
11
Phoebe Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.4]
b. 13 Aug 1813 d. 18 Nov 1846
Benjamin Bengraw Shaw
b. 1808
12
Clymenia Azuba Shaw
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.4.1]
b. 2 Feb 1834 d. 10 Aug 1920 [
=>
]
Benjamin Gibson
b. 9 May 1805 d. 26 Nov 1897
12
Hannah Gibson
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.4.2]
b. 24 Apr 1836 d. 31 Oct 1846
12
Isabella Amy Gibson
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.4.3]
b. 20 Mar 1838 d. 11 Feb 1898 [
=>
]
12
Mary Jane Gibson
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.4.4]
b. 5 Feb 1840 d. 12 Jun 1912 [
=>
]
12
Susan Jane Gibson
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.4.5]
b. 11 Oct 1842 d. 25 May 1929 [
=>
]
12
Jemima Gibson
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.4.6]
b. 1847
11
Carum Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.5]
b. 12 Aug 1815 d. 1843
11
Gerua Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.6]
b. 12 Aug 1815 d. 18 Sep 1848
11
Nelson Wheeler Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.7]
b. 11 Jul 1818 d. 5 Jul 1887
Susan Jane Bailey
b. 9 Mar 1828 d. 5 Jun 1856
12
Son Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.1]
b. 15 Oct 1844 d. 15 Oct 1844
12
Miranda Jane Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.2]
b. 14 Mar 1847 d. 29 Dec 1907 [
=>
]
12
Mary Janet Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.3]
b. 14 Feb 1849 d. Nov 1922 [
=>
]
12
George Nelson Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.4]
b. 20 Mar 1851 d. 8 Jun 1912 [
=>
]
12
Edson Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.5]
b. 10 Oct 1853 d. 26 Feb 1909 [
=>
]
12
Harriet Emily Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.6]
b. 21 Nov 1855 d. 4 Oct 1856
12
Annie Bard Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.7]
b. 5 Jun 1856
Susan Ann Gay
b. 13 Jun 1841 d. 29 Sep 1911
12
Martha Ellen Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.8]
b. 19 Jan 1858 d. 20 Oct 1937 [
=>
]
12
Nelson Gay Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.9]
b. 21 Sep 1859 d. 2 Apr 1944 [
=>
]
12
Sylvia Gay Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.10]
b. 18 May 1862 d. 20 Jan 1940 [
=>
]
12
Susan Ann Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.11]
b. 3 Nov 1864 d. 19 Dec 1935 [
=>
]
12
Alexander Samuel Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.12]
b. 2 Mar 1867 d. 8 Jan 1899 [
=>
]
12
Robert John Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.13]
b. 13 Nov 1869 d. 6 Nov 1954 [
=>
]
12
Amey Jane Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.14]
b. 15 Dec 1871 d. 6 Sep 1962 [
=>
]
12
Ida Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.15]
b. 15 Dec 1873 d. 21 May 1956 [
=>
]
12
Anor Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.16]
b. 25 Mar 1879 d. 23 Oct 1967 [
=>
]
Rachel Keeling
b. 10 Mar 1818 d. 16 Jun 1910
12
Daniel Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.17]
b. 12 Apr 1854 d. 12 Feb 1926 [
=>
]
12
Cynthia Delight Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.18]
b. 7 Jun 1857 d. 4 Sep 1858
12
Nelson Wheeler Whipple, Jr
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.2.7.19]
b. 15 Apr 1859 d. 30 Jun 1938 [
=>
]
10
Richard Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.3]
b. Abt 1781 d. 25 May 1862
10
Roswell Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.4]
b. 1783 d. 25 May 1862
Melinda Gates
b. 26 May 1802 d. Abt 1827
11
Abram Gates Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.4.1]
b. 19 Oct 1826 d. 1913
Roxanna Weeks
b. Apr 1835 d. 18 Oct 1911
12
Emma E Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.4.1.1]
b. 22 Jan 1854
Hannah Weeks
b. 14 Oct 1806 d. 7 Apr 1889
11
William Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.4.2]
b. Mar 1834 d. Aft Jun 1900
11
Sarah Ann Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.4.3]
b. Abt 16 Feb 1834 d. 18 Jan 1919
11
Clarissa Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.4.4]
b. Feb 1838 d. 30 Jul 1921
11
Ella Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.4.5]
b. Abt 1839
11
Jane Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.4.6]
b. 1843
11
Emoline Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.4.7]
b. Abt 1848 d. 31 Mar 1923
11
Caroline Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.4.8]
b. Abt 1848
11
Frank E Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.4.9]
b. May 1857 d. Aft 1904
10
Polly Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.5]
b. Abt 1785
10
Lucy Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.6]
b. Abt 1787
+
Bingham
b. 1783
10
Cynthia Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.7]
b. 1789 d. 15 Feb 1856
Ebenezer Root
b. 17 Dec 1760 d. 12 Feb 1842
11
Jerusha Root
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.7.1]
b. 22 Feb 1804 d. 8 Jul 1889
Seth M Johnson
b. 4 Oct 1802 d. 16 Jun 1865
12
Hiram Titus Johnson
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.7.1.1]
b. May 1829 d. 25 Dec 1852
12
Frances Lucia Johnson
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.7.1.2]
b. 1831
12
Daniel Johnson
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.7.1.3]
b. 21 Apr 1833 d. 1915 [
=>
]
12
Charles Johnson
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.7.1.4]
b. 1835
12
Ellen A Johnson
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.7.1.5]
b. 1837 d. 27 Jul 1853
12
Robert L Johnson
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.7.1.6]
b. 1839 d. 18 Nov 1864
12
Mary A Johnson
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.7.1.7]
b. 1842
12
Esther L Johnson
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.7.1.8]
b. 1844
12
Sarah A Johnson
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.7.1.9]
b. 19 Nov 1847
11
Charlotte Root
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.7.2]
b. 5 Jul 1805 d. 26 Oct 1900
Ira Dibble
b. 13 Apr 1795 d. 31 May 1837
12
Ira Wilson Dibble
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.7.2.1]
b. 10 Dec 1827 d. 18 Dec 1902 [
=>
]
12
William Warner Dibble
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.7.2.2]
b. 10 Dec 1833 d. 24 Oct 1895 [
=>
]
11
Polly Root
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.7.3]
b. 16 Apr 1807 d. 9 Dec 1853
11
Daniel W Root
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.7.4]
b. 29 May 1809 d. 23 Oct 1846
11
Harriet Root
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.7.5]
b. 27 Aug 1811 d. 26 Oct 1901
11
Alanson Root
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.7.6]
b. 19 Nov 1814 d. 1817
11
Cyras Root
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.7.7]
b. 10 Feb 1817
11
Silas Root
[1.1.2.1.4.2.1.1.10.7.8]
b. 10 Feb 1817 d. 1 Apr 1904
9
Thomas Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.11]
b. 16 Mar 1751 d. 1833
Lydia Gates
b. Abt 1761 d. 17 Mar 1795
10
Lydia Gates Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.1]
b. 24 Jul 1779 d. 1 Sep 1864
Jonathan Carver Ames
b. 18 Mar 1774 d. 26 Apr 1853
11
Alvin Ames
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.1.1]
b. 8 Mar 1800 d. 11 Jun 1870
Patricia Ames
b. Abt 1802
12
Hamilton E Aymes
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.1.1.1]
b. 1828
12
William Ransom Ames
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.1.1.2]
b. 1831
12
Susan V Aymes
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.1.1.3]
b. 1841
12
Alvin M Aymes
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.1.1.4]
b. 1845
12
Jerusa Ames
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.1.1.5]
11
Chester Ames
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.1.2]
b. 9 May 1801 d. 28 Aug 1891
Susanna D Pitts
b. 2 Sep 1805 d. 26 Apr 1887
12
Caroline Ames
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.1.2.1]
b. 3 Oct 1826 d. 17 Apr 1827
12
Lucille A Ames
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.1.2.2]
b. 22 May 1828 d. 13 May 1909 [
=>
]
12
Apollos Pitts Ames
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.1.2.3]
b. 22 May 1830 d. 10 Sep 1899
12
Thomas Whipple Ames
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.1.2.4]
b. 10 May 1832 d. 10 Nov 1917 [
=>
]
12
Alvin Ames
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.1.2.5]
b. Abt 1834
12
Olivia L Ames
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.1.2.6]
b. Aug 1835 d. 28 Dec 1909 [
=>
]
12
Chester L Ames
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.1.2.7]
b. 27 Aug 1839 d. 31 Jul 1897 [
=>
]
12
Mary F Ames
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.1.2.8]
b. 15 Jun 1843 d. 10 Oct 1913
12
Marion Frances Ames
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.1.2.9]
b. 15 Jun 1843 d. 28 Jun 1924 [
=>
]
12
Benjamin Willard Ames
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.1.2.10]
b. 16 Feb 1845 d. 1 Oct 1873
11
Joseph Ames
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.1.3]
b. 28 Sep 1802 d. 11 Apr 1851
Rebecca Ames
b. 1815
12
Sally Ames
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.1.3.1]
b. 1836
12
Simeon Ames
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.1.3.2]
b. 1841
12
Frederick Ames
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.1.3.3]
b. 1846
12
Minerva Ames
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.1.3.4]
b. 1848
11
Mary Ames
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.1.4]
b. 3 Feb 1804 d. 23 Nov 1884
11
Johnathan Carver Ames
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.1.5]
b. 18 Apr 1807 d. 26 Mar 1868
Lucy P Ames
b. Abt 1810 d. Mar 1886
12
Jonathan C Ames
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.1.5.1]
b. 1830
12
Roderick Dhu Ames
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.1.5.2]
b. 2 Sep 1832 d. 31 Mar 1914 [
=>
]
12
Samuel E Ames
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.1.5.3]
b. 27 Dec 1833
11
Thomas Whipple Ames
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.1.6]
b. 7 Apr 1808 d. 18 Jan 1885
11
Walter Whipple Ames
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.1.7]
b. 21 Jun 1810 d. 26 Apr 1887
Amelia Stratten
b. 22 Apr 1821 d. 1 Oct 1905
12
Levi F Ames
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.1.7.1]
b. Mar 1840 d. 16 Jun 1923
12
Albert Ames
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.1.7.2]
b. 1847
12
Adelbert Ames
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.1.7.3]
b. 1848
12
Delbert Calvin Ames
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.1.7.4]
b. 21 Mar 1848 d. 9 Feb 1937
12
Albro Joseph Ames
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.1.7.5]
b. 21 Mar 1851 d. 14 Nov 1934
12
Josephine Emma Ames
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.1.7.6]
b. 1853
12
Emily Ames
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.1.7.7]
b. 1856
11
Caroline Ames
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.1.8]
b. 1 Apr 1811 d. 17 Apr 1828
11
Valeria Ames
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.1.9]
b. 24 Jun 1813 d. 15 Sep 1856
11
Levi Ames
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.1.10]
b. 11 Jun 1816 d. 31 Jul 1909
11
Phoebe Tabor Ames
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.1.11]
b. 18 Jun 1818
Elijah Ames
b. 23 Feb 1813 d. 10 Nov 1885
12
Lydia W Ames
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.1.11.1]
b. 1844 [
=>
]
12
Edmond H Ames
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.1.11.2]
b. 19 Oct 1846 d. 7 Mar 1917 [
=>
]
12
Rizpah Ames
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.1.11.3]
b. 8 Oct 1848 d. 18 May 1917 [
=>
]
12
Truman Ames
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.1.11.4]
b. 25 Jun 1851 d. 20 Mar 1939 [
=>
]
12
Waittie M Ames
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.1.11.5]
b. Sep 1854
12
Patsy L Ames
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.1.11.6]
b. Feb 1858
12
Luella Ames
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.1.11.7]
b. 6 Jan 1860 d. 10 Oct 1943
11
Lydia Whipple Ames
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.1.12]
b. 15 Nov 1820 d. 25 Feb 1903
Benjamin F Knowlton
b. 6 Dec 1822 d. 4 Jun 1906
12
George C Knowlton
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.1.12.1]
b. Oct 1846 d. 14 Oct 1922 [
=>
]
12
Phebe A Knowlton
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.1.12.2]
b. Oct 1852 d. Jul 1937 [
=>
]
12
Eugene F Knowlton
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.1.12.3]
b. Sep 1854 d. 11 May 1938 [
=>
]
10
Thomas Jefferson Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.2]
b. 1787 d. 23 Jan 1835
Phebe Taber
b. Aug 1784 d. 17 Aug 1823
11
Alonzo A Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.2.1]
b. 27 Feb 1811 d. 11 Mar 1887
Deborah D Parker
b. 1814 d. 11 Aug 1873
12
Thomas D Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.2.1.1]
b. Abt 1836 d. Bef 1913
12
Alonzo A Whipple, Jr
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.2.1.2]
b. Abt 1838 d. 13 Jul 1869 [
=>
]
12
Rhoda A Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.2.1.3]
b. 30 May 1838 d. 28 Aug 1910 [
=>
]
12
George F Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.2.1.4]
b. Abt 1840 d. Bef 1913
12
Lewis B Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.2.1.5]
b. 13 Jun 1842 d. 13 Jul 1867
12
Deborah Parker Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.2.1.6]
b. 20 Mar 1845 d. 19 May 1913 [
=>
]
12
Mary Frances Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.2.1.7]
b. 1850
12
Walter G Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.2.1.8]
b. Abt 1854 d. Aft 1913
11
Thomas Jefferson Whipple, Jr
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.2.2]
b. 30 Jan 1816 d. 21 Dec 1889
Belinda Butler Hadley
b. 1 May 1820 d. 14 Nov 1854
12
Belinda Caroline Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.2.2.1]
b. 18 Aug 1846 d. Aft 1889 [
=>
]
11
Caroline B Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.2.3]
b. 1 Apr 1820 d. 5 Oct 1910
George Flanders
b. 17 May 1822 d. 2 Mar 1895
12
Caroline M Flanders
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.2.3.1]
b. Jan 1851 d. 17 Sep 1851
12
Emily Flanders
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.2.3.2]
b. 19 Jan 1854
10
Mattie Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.3]
b. 8 May 1789 d. 4 Sep 1877
Paul Tabor
b. 12 Aug 1788 d. 3 Sep 1878
11
Mialma Tabor
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.3.1]
b. 8 Jan 1814 d. 26 Aug 1894
John Densmore
b. 18 Nov 1805 d. 19 Sep 1851
12
Sarah E Densmore
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.3.1.1]
b. 1838
12
John Densmore
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.3.1.2]
b. 1840
12
Marietta Tabor Densmore
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.3.1.3]
b. 11 Jul 1843 d. 1 Oct 1915 [
=>
]
12
Isabella Densmore
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.3.1.4]
b. 1845
12
Amanda Densmore
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.3.1.5]
b. 14 Apr 1848 [
=>
]
11
Ann Tabor
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.3.2]
b. 5 Jul 1828 d. 29 Nov 1904
Lucien Bonaparte Bowen
b. 8 Aug 1817 d. 27 Oct 1863
12
Mary Bowen
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.3.2.1]
b. 13 Dec 1848 d. 13 Jan 1849
12
Florence Bowen
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.3.2.2]
b. 31 Jan 1850 d. 31 Dec 1878
12
Paul Tabor Bowen
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.3.2.3]
b. 9 Mar 1852
12
George Wood Bowen
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.3.2.4]
b. 4 Mar 1854
12
Laurah Jessie Bowen
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.3.2.5]
b. 30 Jan 1856 d. 15 Jan 1859
12
Annie Patience Bowen
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.3.2.6]
b. 21 Feb 1858 [
=>
]
12
Luciene Bowen
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.3.2.7]
b. Dec 1861 d. Jan 1862
10
Son Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.4]
b. Bef 1790 d. Aft 1790
10
Walter Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.5]
b. 28 Feb 1792 d. 24 Dec 1882
Susan A Donaldson
b. Abt 1795
11
Lothario Danielson Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.5.1]
b. 14 Sep 1831 d. 18 Nov 1847
Ruth Baker
b. Abt 1806 d. Aft 1880
11
Susan Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.5.2]
b. 1846
11
James Henry Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.5.3]
b. Dec 1857
Emma Amelia Packard
b. 9 May 1851 d. 19 May 1939
12
Maggie Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.5.3.1]
b. 25 Aug 1871
12
George C Whipple
[1.1.2.1.4.2.1.1.11.5.3.2]
b. 20 Jul 1875 d. 11 Feb 1922
8
Jerusha Jones
[1.1.2.1.4.2.1.2]
b. 8 Apr 1711 d. 28 Oct 1763
Jonathan Spencer
b. 15 Mar 1704 d. 19 May 1763
9
Jerusha Spencer
[1.1.2.1.4.2.1.2.1]
b. 6 May 1732 d. 21 Feb 1815
9
Jonathan Spencer
[1.1.2.1.4.2.1.2.2]
b. 11 Mar 1734 d. 16 Jul 1813
9
Obadiah Spencer
[1.1.2.1.4.2.1.2.3]
b. 7 Mar 1735 d. 1806
9
Ruth Spencer
[1.1.2.1.4.2.1.2.4]
b. 12 Feb 1737
9
Israel Spencer
[1.1.2.1.4.2.1.2.5]
b. 14 Feb 1740 d. 22 Sep 1747
9
Zachariah Spencer
[1.1.2.1.4.2.1.2.6]
b. 28 Mar 1742 d. 4 Oct 1762
9
Jehid Spencer
[1.1.2.1.4.2.1.2.7]
b. 17 Feb 1744 d. 16 Sep 1747
9
Jehiel Spencer
[1.1.2.1.4.2.1.2.8]
b. 17 Feb 1747 d. 24 Feb 1816
9
Israel Spencer
[1.1.2.1.4.2.1.2.9]
b. Abt 1748 d. 22 Jan 1825
9
Hulda Spencer
[1.1.2.1.4.2.1.2.10]
b. 7 Jan 1750
9
Sybil Spencer
[1.1.2.1.4.2.1.2.11]
b. 17 Mar 1759
8
Thomas Jones
[1.1.2.1.4.2.1.3]
b. 15 Mar 1712 d. 1746
+
Sarah Parsons
b. 10 Mar 1704 d. 25 Aug 1747
8
Bathsheba Jones
[1.1.2.1.4.2.1.4]
b. 16 Feb 1714 d. 12 May 1715
8
Captain Israel Jones
[1.1.2.1.4.2.1.5]
b. 18 May 1715 d. 28 Dec 1798
Jemima Clark
b. 5 Mar 1726 d. 3 Jun 1798
9
Israel Jones
[1.1.2.1.4.2.1.5.1]
b. 2 Sep 1753 d. 1 Sep 1812
9
Jemima Jones
[1.1.2.1.4.2.1.5.2]
b. 5 Jun 1755 d. 22 Dec 1818
9
Samuel Jones
[1.1.2.1.4.2.1.5.3]
b. 31 Jan 1745 d. 4 Sep 1747
9
William Clark Jones
[1.1.2.1.4.2.1.5.4]
b. Abt 1771
9
Thomas Jones
[1.1.2.1.4.2.1.5.5]
b. 1751 d. 1832
9
Mary Jones
[1.1.2.1.4.2.1.5.6]
b. Abt 1745 d. Abt 1826
9
Isaac Jones
[1.1.2.1.4.2.1.5.7]
b. 25 Apr 1764 d. 16 Jul 1830
9
Submit Jones
[1.1.2.1.4.2.1.5.8]
b. 18 Oct 1757 d. 29 Dec 1785
8
Isaac Jones
[1.1.2.1.4.2.1.6]
b. 29 Jan 1717 d. 3 Jul 1784
+
Elizabeth
b. Abt 1718
8
Bathsheba Jones
[1.1.2.1.4.2.1.7]
b. 25 Feb 1720 d. 9 Jan 1775
John Pease
b. 1726 d. Abt 1810
9
John Chauncey Pease
[1.1.2.1.4.2.1.7.1]
b. Abt 1750 d. 1843
9
Thomas Pease
[1.1.2.1.4.2.1.7.2]
c. 17 Dec 1754 d. 2 Feb 1810
9
Gideon Pease
[1.1.2.1.4.2.1.7.3]
b. 18 Nov 1757 d. 1824
9
Elizabeth Pease
[1.1.2.1.4.2.1.7.4]
b. 29 May 1756 d. 24 Sep 1827
9
Bathsheba Pease
[1.1.2.1.4.2.1.7.5]
b. 1759
9
Sarah Pease
[1.1.2.1.4.2.1.7.6]
b. 14 May 1762
9
Simeon Pease
[1.1.2.1.4.2.1.7.7]
b. Abt 1764 d. 1827
8
Elizabeth Jones
[1.1.2.1.4.2.1.8]
b. 1722 d. 1804
David Kellogg
b. Abt 1718 d. 6 Mar 1747
9
Mary Kellogg
[1.1.2.1.4.2.1.8.1]
b. 13 Jun 1748 d. 20 Jun 1810
9
Samuel Kellogg
[1.1.2.1.4.2.1.8.2]
b. 6 Aug 1749
9
David Kellogg
[1.1.2.1.4.2.1.8.3]
b. 16 Nov 1750 d. 22 Apr 1774
9
Elizabeth Kellogg
[1.1.2.1.4.2.1.8.4]
b. 15 Aug 1752 d. 15 Mar 1807
9
Seth Kellogg
[1.1.2.1.4.2.1.8.5]
b. 14 Mar 1754 d. 20 Jun 1801
9
Phineas Kellogg
[1.1.2.1.4.2.1.8.6]
b. 6 Apr 1756 d. 26 Jul 1806
9
Ruth Kellogg
[1.1.2.1.4.2.1.8.7]
b. 3 Sep 1757 d. 14 Jun 1837
9
Enoch Kellogg
[1.1.2.1.4.2.1.8.8]
b. 12 Jul 1759 d. 31 Aug 1759
9
Elzina Kellogg
[1.1.2.1.4.2.1.8.9]
b. Abt 1761
9
Lucretia Kellogg
[1.1.2.1.4.2.1.8.10]
b. Abt 1763 d. 14 Jun 1814
9
Enoch Kellogg
[1.1.2.1.4.2.1.8.11]
b. 9 Oct 1768 d. 29 Oct 1847
8
Samuel Jones
[1.1.2.1.4.2.1.9]
b. 29 Oct 1724 d. 19 Sep 1743
+
Anna Taylor
b. Abt 1727
8
Son Jones
[1.1.2.1.4.2.1.10]
b. Abt 1726
7
Priscilla Jones
[1.1.2.1.4.2.2]
b. 10 Jun 1681 d. Aft 1719
John Howard
b. 1683
8
Elezebath Howard
[1.1.2.1.4.2.2.1]
b. 20 May 1707
8
Priscilla Howard
[1.1.2.1.4.2.2.2]
b. 20 Sep 1705 bur. Abt 1759
8
John Howard
[1.1.2.1.4.2.2.3]
b. 24 May 1719
7
Benjamin Jones
[1.1.2.1.4.2.3]
b. 1683 d. 5 Feb 1754
Anna Prior
b. 30 Mar 1690 d. 5 Feb 1754
8
Benjamin Jones
[1.1.2.1.4.2.3.1]
b. 9 Jun 1710 d. 13 Oct 1794
8
Joseph Jones
[1.1.2.1.4.2.3.2]
b. 3 Jan 1712 d. 26 Jan 1757
Sarah Wood
b. Abt 1712
9
Joseph Jones
[1.1.2.1.4.2.3.2.1]
b. 1 Nov 1734 d. 29 Jan 1816
Sarah Mead
b. 10 Aug 1735 d. 21 Dec 1822
10
Thomas Jones
[1.1.2.1.4.2.3.2.1.1]
b. 1762 d. 25 Jul 1842
Susanna Susan Ramsey
b. 1770 d. 1851
11
Susanne Jones
[1.1.2.1.4.2.3.2.1.1.1]
b. 1789
11
Mary Jones
[1.1.2.1.4.2.3.2.1.1.2]
b. 1792
11
Esquire M Jones
[1.1.2.1.4.2.3.2.1.1.3]
b. 1792 d. 1891
11
Rebecca Jones
[1.1.2.1.4.2.3.2.1.1.4]
b. 1795 d. 1880
11
Elizabeth Jones
[1.1.2.1.4.2.3.2.1.1.5]
b. 1798 d. 1880
11
Daniel Jones
[1.1.2.1.4.2.3.2.1.1.6]
b. 1802
11
William Jones
[1.1.2.1.4.2.3.2.1.1.7]
b. 10 Feb 1800 d. 1850
Artymes Johannes
b. 22 Aug 1802 d. 3 Oct 1884
12
William H Jones
[1.1.2.1.4.2.3.2.1.1.7.1]
b. 17 Nov 1824 d. 13 Jun 1909 [
=>
]
12
George Washington Jones
[1.1.2.1.4.2.3.2.1.1.7.2]
b. May 1827 d. 13 Nov 1903
12
Andrew Jackson Jones
[1.1.2.1.4.2.3.2.1.1.7.3]
b. Abt 1832 d. 20 Apr 1907
12
Nancy Jones
[1.1.2.1.4.2.3.2.1.1.7.4]
b. Abt 1834 d. Abt 1866
12
Leander David Jones
[1.1.2.1.4.2.3.2.1.1.7.5]
b. 22 Nov 1838 d. 26 Feb 1925 [
=>
]
12
Francis Marion Jones
[1.1.2.1.4.2.3.2.1.1.7.6]
b. 1 Jan 1841 d. 17 Apr 1933 [
=>
]
12
Susan Ellen Jones
[1.1.2.1.4.2.3.2.1.1.7.7]
b. 5 Mar 1843 d. 6 Sep 1919 [
=>
]
12
Marshall Bruce Jones
[1.1.2.1.4.2.3.2.1.1.7.8]
b. 9 Feb 1846 d. 8 Mar 1885 [
=>
]
11
John Ramsey Jones
[1.1.2.1.4.2.3.2.1.1.8]
b. 17 Nov 1806 d. 1880
Catherine Morrell
b. Abt 1808
12
Montraville Jones
[1.1.2.1.4.2.3.2.1.1.8.1]
b. 1832
12
Charlotte Jones
[1.1.2.1.4.2.3.2.1.1.8.2]
b. 1834 d. 20 May 1926
12
Squire M. Jones
[1.1.2.1.4.2.3.2.1.1.8.3]
b. Sep 1835 d. 28 Dec 1905
11
Stacy Jones
[1.1.2.1.4.2.3.2.1.1.9]
b. 1805 d. 1849
11
Eliza Jones
[1.1.2.1.4.2.3.2.1.1.10]
b. 1809
11
Catherine Jones
[1.1.2.1.4.2.3.2.1.1.11]
b. 1811 d. 1885
9
Tryphena Jones
[1.1.2.1.4.2.3.2.2]
b. 22 Mar 1737
9
Silas Jones
[1.1.2.1.4.2.3.2.3]
b. 1 Apr 1740
9
Daniel Jones
[1.1.2.1.4.2.3.2.4]
b. 31 Jan 1743 d. 23 Mar 1792
9
Esther Jones
[1.1.2.1.4.2.3.2.5]
b. Abt 1757 d. 1821
8
Annie Jones
[1.1.2.1.4.2.3.3]
b. 9 Sep 1714 d. 22 Sep 1808
8
Levi Jones
[1.1.2.1.4.2.3.4]
b. 9 Nov 1716 d. 23 May 1766
8
Abi Jones
[1.1.2.1.4.2.3.5]
b. 15 Mar 1718
8
Hannah Jones
[1.1.2.1.4.2.3.6]
b. 23 Sep 1720 d. 11 Oct 1806
8
Naomi Jones
[1.1.2.1.4.2.3.7]
b. 28 Mar 1721
8
Zebblon Jones
[1.1.2.1.4.2.3.8]
b. 9 Jun 1723 d. 27 Sep 1776
8
Lucrettia Jones
[1.1.2.1.4.2.3.9]
b. 1729
7
Ebenezer Jones
[1.1.2.1.4.2.4]
b. 17 Apr 1684 d. 20 Jul 1755
Priscilla Smith
b. Abt 1684 d. Bef 1725
8
Elezebath Jones
[1.1.2.1.4.2.4.1]
b. 11 May 1713
8
Ebenezer Jones
[1.1.2.1.4.2.4.2]
b. 12 Jan 1715
8
Gersham Jones
[1.1.2.1.4.2.4.3]
b. 1717
8
Hannah Jones
[1.1.2.1.4.2.4.4]
b. 11 Jul 1720 d. 8 Jul 1764
8
Martha Jones
[1.1.2.1.4.2.4.5]
b. Abt 1721
Jemima Gary
b. 10 Mar 1705 d. Aft 1747
8
North Jones
[1.1.2.1.4.2.4.6]
b. 18 Apr 1731
8
Zerviah Jones
[1.1.2.1.4.2.4.7]
b. 28 Mar 1734
8
Abigail Jones
[1.1.2.1.4.2.4.8]
b. 4 Jan 1735
8
Nathan Jones
[1.1.2.1.4.2.4.9]
b. Jun 1738
8
Thomas Jones
[1.1.2.1.4.2.4.10]
b. 30 Aug 1741 d. 13 Oct 1762
8
Margan Jones
[1.1.2.1.4.2.4.11]
b. 8 Aug 1747
7
Elizabeth Jones
[1.1.2.1.4.2.5]
b. 26 Jan 1685 d. 2 Jan 1769
Isaac Osborn
b. Abt 1680
8
George Osborn
[1.1.2.1.4.2.5.1]
c. 20 Oct 1724
7
Ephraim Jones
[1.1.2.1.4.2.6]
b. 31 Jul 1688 d. 3 Sep 1688
7
Samuel Jones
[1.1.2.1.4.2.7]
b. 22 Sep 1690 d. 4 Nov 1691
7
Eleazer Jones
[1.1.2.1.4.2.8]
b. 12 Apr 1693 d. 20 Apr 1755
Mehitable Gary
b. 11 Jul 1697 d. Aft 1735
8
Son Jones
[1.1.2.1.4.2.8.1]
b. 21 May 1721 d. 26 Jun 1721
8
Eleazer Jones
[1.1.2.1.4.2.8.2]
b. 26 Jan 1723 d. 23 May 1758
8
Mehitable Jones
[1.1.2.1.4.2.8.3]
b. 4 Jun 1725 d. 28 Apr 1766
8
Elizabeth Jones
[1.1.2.1.4.2.8.4]
b. 23 Jul 1727 d. 28 Apr 1766
8
Benjamin Jones
[1.1.2.1.4.2.8.5]
b. 8 May 1730
8
Ebenezer Jones
[1.1.2.1.4.2.8.6]
7
Gersham Jones
[1.1.2.1.4.2.9]
b. 26 Oct 1695 d. 19 Oct 1696
6
Priscilla Wildes
[1.1.2.1.4.3]
b. 6 Apr 1658 d. 23 Mar 1688
6
Martha Wildes
[1.1.2.1.4.4]
b. 13 May 1660 d. 1685
6
Nathan Wildes
[1.1.2.1.4.5]
b. 14 Dec 1662 d. 17 Mar 1663
5
John Gould
[1.1.2.1.5]
b. 21 Jun 1635 d. 26 Jan 1710
Sarah Baker
b. 9 Mar 1641 d. 20 Jan 1709
6
John Gould
[1.1.2.1.5.1]
b. 1 Dec 1662 d. 5 Nov 1724
6
Sarah Gould
[1.1.2.1.5.2]
b. 18 Dec 1664 d. 4 Dec 1723
6
Thomas Gould
[1.1.2.1.5.3]
b. 14 Feb 1666 d. 24 Jun 1752
6
Samuel Gould
[1.1.2.1.5.4]
b. 9 Mar 1669 d. 1 Dec 1724
6
Zaccheus Gould
[1.1.2.1.5.5]
b. 26 Mar 1672 d. 29 Apr 1739
Elizabeth Curtis
b. 15 Dec 1679 d. 21 Jun 1740
7
Elizabeth Gould
[1.1.2.1.5.5.1]
b. 3 Feb 1703 d. 17 Sep 1742
Edmund Towne
b. 7 May 1699 d. 27 May 1745
8
Eliza Goold
[1.1.2.1.5.5.1.1]
b. 29 Dec 1723
8
Debora Goold
[1.1.2.1.5.5.1.2]
b. Abt 1724 d. 12 Mar 1812
8
Mehitabel Goold
[1.1.2.1.5.5.1.3]
b. 10 Nov 1728
8
Edmund Towne
[1.1.2.1.5.5.1.4]
b. 10 Sep 1733
8
Nathaniel Gould
[1.1.2.1.5.5.1.5]
b. 17 Nov 1734 d. Dec 1781
8
Zaccheus Town
[1.1.2.1.5.5.1.6]
b. 20 Feb 1736 d. 1740
8
Bathsheba Towne
[1.1.2.1.5.5.1.7]
b. 28 Mar 1740 d. 1741
8
Mary Towne
[1.1.2.1.5.5.1.8]
b. 7 Sep 1742 d. 1742
7
Mary Gould
[1.1.2.1.5.5.2]
c. 1 Mar 1704 d. 3 Nov 1787
7
John Gould
[1.1.2.1.5.5.3]
b. 29 Jan 1709 d. 21 Jun 1778
7
Sarah Gould
[1.1.2.1.5.5.4]
b. 28 Jan 1711 d. 1743
7
Abigail Gould
[1.1.2.1.5.5.5]
b. 12 Aug 1715 d. Abt 1737
7
Zaccheus Gould
[1.1.2.1.5.5.6]
b. 7 Nov 1717 d. 2 Jan 1793
7
Eleazar Gould
[1.1.2.1.5.5.7]
b. 29 May 1720 d. Jun 1795
Elizabeth Smith
b. 8 Jul 1718 d. 27 Mar 1753
8
Zaccheus Gould
[1.1.2.1.5.5.7.1]
b. 5 Feb 1743 d. 13 Feb 1823
8
John Gould
[1.1.2.1.5.5.7.2]
b. 5 Mar 1745
8
Hulda Gould
[1.1.2.1.5.5.7.3]
b. 1 Aug 1748 d. 11 Oct 1748
7
Susannah Gould
[1.1.2.1.5.5.8]
b. 19 Feb 1723 d. Abt 1773
Robert Smith
b. 28 Feb 1724 d. 17 Mar 1795
8
Elijah Smith
[1.1.2.1.5.5.8.1]
b. 5 Dec 1746 d. 5 Nov 1839
8
Elisha Smith
[1.1.2.1.5.5.8.2]
b. 4 Oct 1748
8
Joseph Smith
[1.1.2.1.5.5.8.3]
b. 9 Jun 1751
8
Elizabeth Smith
[1.1.2.1.5.5.8.4]
b. 20 Apr 1753 d. 10 Apr 1797
8
Rebeckah Smith
[1.1.2.1.5.5.8.5]
b. 8 May 1758 d. 8 Sep 1839
8
Thomas Smith
[1.1.2.1.5.5.8.6]
b. 10 Mar 1760 d. 3 Oct 1846
8
Silas Smith
[1.1.2.1.5.5.8.7]
b. 30 May 1772
8
Jedediah Smith
[1.1.2.1.5.5.8.8]
b. 30 May 1772
7
Priscilla Gould
[1.1.2.1.5.5.9]
b. 4 Aug 1707 d. 25 Sep 1744
Captain Samuel T Smith
b. 26 Jan 1714 d. 14 Nov 1785
8
Priscilla Smith
[1.1.2.1.5.5.9.1]
b. 26 Dec 1735 d. 7 Dec 1792
Jacob Kimball
b. 5 Mar 1731 d. 8 Nov 1810
9
Benjamin Kimball
[1.1.2.1.5.5.9.1.1]
b. 23 Jan 1757 d. 19 Aug 1776
9
Mehetiball Kimbal
[1.1.2.1.5.5.9.1.2]
b. 3 Dec 1758 d. 12 Nov 1790
9
Jacob Kimball
[1.1.2.1.5.5.9.1.3]
b. 2 Feb 1761 d. 24 Jul 1826
9
Priscilla Kimball
[1.1.2.1.5.5.9.1.4]
b. 10 Mar 1763 d. 2 Sep 1792
9
Ann Kimball
[1.1.2.1.5.5.9.1.5]
b. 2 Jun 1765 d. 12 Sep 1789
9
Lucy Kimball
[1.1.2.1.5.5.9.1.6]
b. 6 Sep 1767 bur. Sep 1790
9
Lydia Kimball
[1.1.2.1.5.5.9.1.7]
b. 28 Jan 1770 d. 20 Apr 1795
9
David Kimball
[1.1.2.1.5.5.9.1.8]
b. 26 Apr 1772 d. 20 Nov 1795
9
Samuel Kimball
[1.1.2.1.5.5.9.1.9]
b. Dec 1774 d. 10 Sep 1775
8
Samuel Smith, III
[1.1.2.1.5.5.9.2]
b. 28 Oct 1737 d. 14 Nov 1785
Rebecca Lovett
b. 9 Jun 1737 d. Aft 1760
9
Rebekah Smith
[1.1.2.1.5.5.9.2.1]
b. 29 Jun 1760 d. 15 Apr 1816
9
Lydia Smith
[1.1.2.1.5.5.9.2.2]
b. 14 Apr 1762 d. 19 Dec 1850
Jacob Wilds
b. Abt 1780 d. 16 Jan 1841
10
Mary Wilds
[1.1.2.1.5.5.9.2.2.1]
b. Sep 1787 d. 29 Feb 1856
10
Moses Wilds
[1.1.2.1.5.5.9.2.2.2]
b. 8 Oct 1790 d. 1 Nov 1879
Abigail King
b. 10 Jun 1800 d. 25 Aug 1887
11
Mary Wilds
[1.1.2.1.5.5.9.2.2.2.1]
b. 14 Feb 1818 d. 21 Apr 1895
Nathan A Smith
b. 12 Feb 1820 d. 11 Apr 1888
12
Lydia Smith
[1.1.2.1.5.5.9.2.2.2.1.1]
b. 4 Aug 1847 d. 22 Nov 1937
12
Carlos William Smith
[1.1.2.1.5.5.9.2.2.2.1.2]
b. 18 Aug 1852 d. 2 May 1928 [
=>
]
11
Lydia Wilds
[1.1.2.1.5.5.9.2.2.2.2]
b. 4 Feb 1820
Thomas Jefferson Dickey
b. 10 Dec 1808 d. 1 Feb 1881
12
Henry Dickey
[1.1.2.1.5.5.9.2.2.2.2.1]
b. 1842 d. 1913
12
Clara Ellen Dickey
[1.1.2.1.5.5.9.2.2.2.2.2]
b. 5 Apr 1849 d. 15 Jun 1877 [
=>
]
12
Thomas Jefferson Dickey, Jr
[1.1.2.1.5.5.9.2.2.2.2.3]
b. 26 Jan 1850 d. 26 Mar 1865
12
Rose A Dickey
[1.1.2.1.5.5.9.2.2.2.2.4]
b. 22 Jan 1854 d. 22 Mar 1874
12
Lillian Dickey
[1.1.2.1.5.5.9.2.2.2.2.5]
b. 29 Sep 1859
11
Mehitable "Hittie" Wilds
[1.1.2.1.5.5.9.2.2.2.3]
b. 17 Jun 1826 d. 1 Nov 1910
Richard Peckham Church
b. 27 Nov 1819 d. 27 Nov 1897
12
George King Church
[1.1.2.1.5.5.9.2.2.2.3.1]
b. 1 May 1844 d. 1937 [
=>
]
12
Lydia Church
[1.1.2.1.5.5.9.2.2.2.3.2]
b. 1846
12
Flora Church
[1.1.2.1.5.5.9.2.2.2.3.3]
b. Abt 30 Apr 1856 d. 31 Aug 1859
12
Floran A Church
[1.1.2.1.5.5.9.2.2.2.3.4]
b. 15 May 1859 d. 14 Dec 1931 [
=>
]
11
Sally J Wilds
[1.1.2.1.5.5.9.2.2.2.4]
b. Abt 1828
Christopher Columbus Payne
b. 28 Sep 1828 d. 1 Dec 1883
12
Wilson A Payne
[1.1.2.1.5.5.9.2.2.2.4.1]
b. 1851 d. 1926
12
Abbie S Payne
[1.1.2.1.5.5.9.2.2.2.4.2]
b. 1854 [
=>
]
12
Dwight C Payne
[1.1.2.1.5.5.9.2.2.2.4.3]
b. May 1868 d. 4 Apr 1870
11
Cynthia C Wilds
[1.1.2.1.5.5.9.2.2.2.5]
b. 30 Aug 1831 d. 26 May 1930
+
Samuel G Saville
b. 28 Nov 1828 d. 1 Dec 1918
10
Asa Wilds
[1.1.2.1.5.5.9.2.2.3]
b. Abt 1795 d. Abt 1831
10
Nancy Wilds
[1.1.2.1.5.5.9.2.2.4]
b. 12 May 1798 d. 4 Dec 1884
10
William Wilds
[1.1.2.1.5.5.9.2.2.5]
b. 16 Jan 1800 d. 16 Feb 1876
Sarah King
b. 19 Jan 1804 d. 13 Mar 1866
11
Diantha Wilds
[1.1.2.1.5.5.9.2.2.5.1]
b. 2 Dec 1831
Aaron Bunnell Sargent
b. 7 Jun 1829
12
Mary S Sargent
[1.1.2.1.5.5.9.2.2.5.1.1]
b. 24 Jun 1852 d. 19 Apr 1902 [
=>
]
11
Diana Wilds
[1.1.2.1.5.5.9.2.2.5.2]
b. 2 Dec 1831
Almon Richardson Thurston
b. Abt 1829
12
Emma Thurston
[1.1.2.1.5.5.9.2.2.5.2.1]
b. 1858
12
Claira C. Thurston
[1.1.2.1.5.5.9.2.2.5.2.2]
b. 28 Jun 1859
11
Merrill F Wilds
[1.1.2.1.5.5.9.2.2.5.3]
b. 23 Dec 1832 d. 27 Jul 1903
Satira Bradford
b. Abt 10 Apr 1842 d. 20 Oct 1897
12
Etta May Wilds
[1.1.2.1.5.5.9.2.2.5.3.1]
b. 21 Jun 1866 d. 22 Dec 1933 [
=>
]
12
Rosie Emma Wilds
[1.1.2.1.5.5.9.2.2.5.3.2]
b. 21 Apr 1870 d. 27 Dec 1903 [
=>
]
11
Sarah King Wilds
[1.1.2.1.5.5.9.2.2.5.4]
b. 2 May 1834 d. 29 Jan 1906
Charles Poole
b. Abt 1830 d. 27 Jan 1906
12
Edward C Poole
[1.1.2.1.5.5.9.2.2.5.4.1]
b. 1 Nov 1854
12
Ada M Poole
[1.1.2.1.5.5.9.2.2.5.4.2]
b. 9 Nov 1856 d. 18 Jul 1890
12
Gertrude S Poole
[1.1.2.1.5.5.9.2.2.5.4.3]
b. 21 Jun 1863 [
=>
]
12
William Everett Poole
[1.1.2.1.5.5.9.2.2.5.4.4]
b. 13 Jun 1867
11
Louisa Wilds
[1.1.2.1.5.5.9.2.2.5.5]
b. 13 Dec 1838 d. 26 Dec 1893
Alexander Franklin Hayward
b. 11 Apr 1836 d. 4 Jul 1911
12
Ernest Franklin Hayward
[1.1.2.1.5.5.9.2.2.5.5.1]
b. 1 Oct 1874 d. 17 May 1951 [
=>
]
11
Almira Elizabeth Wilds
[1.1.2.1.5.5.9.2.2.5.6]
b. 11 Sep 1840 d. 21 Feb 1906
Charles Howard Beede
b. 3 Aug 1839 d. 4 Apr 1911
12
Clinton Horatio Beede
[1.1.2.1.5.5.9.2.2.5.6.1]
b. 11 Jan 1865 d. 19 Mar 1942 [
=>
]
12
Caroline Adell Beede
[1.1.2.1.5.5.9.2.2.5.6.2]
b. 28 Apr 1868 d. 12 Sep 1934 [
=>
]
12
Rose Emma Beede
[1.1.2.1.5.5.9.2.2.5.6.3]
b. 1 Nov 1871 d. 17 Nov 1919 [
=>
]
12
Bertha Alice Beede
[1.1.2.1.5.5.9.2.2.5.6.4]
b. 22 Oct 1877 d. 27 May 1932 [
=>
]
12
Ada May Beede
[1.1.2.1.5.5.9.2.2.5.6.5]
b. 26 May 1881 d. 13 Aug 1881
11
John K Wilds
[1.1.2.1.5.5.9.2.2.5.7]
d. 5 Feb 1909
Eunice M Dexter
b. 17 Feb 1831 d. 29 May 1898
12
Elwin Aaron Wilds
[1.1.2.1.5.5.9.2.2.5.7.1]
b. 9 Dec 1859 d. 2 Jul 1932 [
=>
]
+
Alice Curtis
b. Abt 1850
10
Susan Wilds
[1.1.2.1.5.5.9.2.2.6]
b. 16 Mar 1803 d. 18 Jan 1869
9
Susanna Smith
[1.1.2.1.5.5.9.2.3]
b. 9 Mar 1764 d. 18 Sep 1781
9
Samuel Smith
[1.1.2.1.5.5.9.2.4]
b. 1 Apr 1766 d. 21 Mar 1811
9
Elizabeth Mary Smith
[1.1.2.1.5.5.9.2.5]
b. 31 Mar 1768
9
Jacob Smith
[1.1.2.1.5.5.9.2.6]
b. 24 May 1770
9
Anna Smith
[1.1.2.1.5.5.9.2.7]
b. 8 Jan 1772
9
Son Smith
[1.1.2.1.5.5.9.2.8]
b. 13 Apr 1773
9
Benjamin Smith
[1.1.2.1.5.5.9.2.9]
b. 20 Feb 1776 d. 2 Oct 1778
8
Vashti Smith
[1.1.2.1.5.5.9.3]
b. 5 Oct 1739 d. Aft 1776
Jacobs Hobbs
b. 16 Jun 1745 d. 20 Jan 1823
9
Jacob Hobbs
[1.1.2.1.5.5.9.3.1]
b. 21 Feb 1768
9
Abraham Hobbs
[1.1.2.1.5.5.9.3.2]
b. 16 Dec 1769
9
Samuel Hobbs
[1.1.2.1.5.5.9.3.3]
b. 21 Feb 1772
9
Vashti Hobbs
[1.1.2.1.5.5.9.3.4]
b. 2 Feb 1774 d. 14 Feb 1836
9
Abigail Hobbs
[1.1.2.1.5.5.9.3.5]
b. 10 Aug 1776
Soloman Curtis
b. 10 Jul 1739 d. Apr 1766
9
Solomon Curtis
[1.1.2.1.5.5.9.3.6]
b. 13 Apr 1766
8
Susannah Smith
[1.1.2.1.5.5.9.4]
b. 24 Jan 1741 d. 13 May 1766
Isaac Hobbs
b. 20 Apr 1743 d. 3 Jun 1815
9
Sarah Hobbs
[1.1.2.1.5.5.9.4.1]
b. 16 Nov 1766 d. 27 Jan 1823
9
Susannah Hobbs
[1.1.2.1.5.5.9.4.2]
b. 16 Nov 1766 d. Abt 1870
9
Priscilla Hobbs
[1.1.2.1.5.5.9.4.3]
b. 28 May 1769 d. 18 May 1771
9
Isaac Hobbs
[1.1.2.1.5.5.9.4.4]
b. 19 Aug 1770 d. Abt 1870
9
Elizabeth Hobbs
[1.1.2.1.5.5.9.4.5]
b. 16 Jan 1773 d. 14 Nov 1850
9
Munson Hobbs
[1.1.2.1.5.5.9.4.6]
b. 5 Mar 1775 d. Abt 1870
9
Samuel Hobbs
[1.1.2.1.5.5.9.4.7]
b. 1 Dec 1776 d. Abt 1870
9
Humphrey Hobbs
[1.1.2.1.5.5.9.4.8]
b. 5 Sep 1779 d. Abt 1870
9
Solomon Hobbs
[1.1.2.1.5.5.9.4.9]
b. 1782 d. 2 May 1854
8
Asael Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5]
b. 7 Mar 1744 d. 31 Oct 1830
Mary Elizabeth Duty
b. 11 Oct 1743 d. 27 May 1836
9
Jesse Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.1]
b. 20 Apr 1768 d. 16 Mar 1793
Hannah Peabody
b. 1771 d. 28 Sep 1849
10
Benjamin Peabody Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.1]
b. 2 May 1793 d. 15 Jan 1850
Lois Crandall
b. 3 Nov 1799 d. 10 Mar 1882
11
Esther Ann Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.1.1]
b. 15 Oct 1823 d. 24 Dec 1900
11
Martha Wallace Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.1.2]
b. 14 Oct 1825 d. 22 May 1849
11
Edwin Wallace Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.1.3]
b. 13 Apr 1827 d. 1 Sep 1907
11
Henry Storrs Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.1.4]
b. 11 Mar 1829 d. 3 Dec 1852
11
Benjamin Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.1.5]
b. 28 Apr 1833 d. 28 May 1833
11
Peabody Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.1.6]
b. 28 Apr 1833 d. 28 May 1833
11
Adeline Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.1.7]
b. 6 May 1834 d. 20 Aug 1911
11
James Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.1.8]
b. 16 Mar 1836 d. 21 Jan 1840
11
Jane Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.1.9]
b. 16 Mar 1836 d. 18 May 1917
11
Lois Ann Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.1.10]
b. 6 Apr 1838 d. 10 Aug 1922
11
Adelia Clarissa Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.1.11]
b. 12 Jul 1841 d. 6 Apr 1908
10
Eliza Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.2]
b. 9 Mar 1795 d. 22 Jul 1870
Stoddard Hunt
b. 14 Feb 1780 d. 10 Dec 1855
11
Daniel Smith Hunt
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.2.1]
b. 10 Dec 1826 d. 19 Feb 1882
11
Esther Hunt
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.2.2]
b. 10 Apr 1828 d. 1915
11
Fanny Hunt
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.2.3]
b. 8 Sep 1829 d. 30 May 1852
11
Jesse Hunt
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.2.4]
b. 7 Apr 1831 d. 17 Apr 1871
11
Stephen Hunt
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.2.5]
b. 16 Nov 1833 d. 16 Nov 1922
11
Royal Hunt
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.2.6]
b. 22 May 1836 d. 23 Dec 1880
11
Eliza Hunt
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.2.7]
b. 1 Aug 1840 d. 27 Nov 1918
10
Ira Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.3]
b. 30 Jan 1797 d. 5 Mar 1874
Lucy Post
11
Harry Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.3.1]
b. 26 Jul 1824 d. 4 Apr 1906
11
Norman E. Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.3.2]
b. 24 Nov 1825 d. 19 May 1918
11
James M. Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.3.3]
b. 2 Aug 1827 d. 21 Oct 1902
11
Esther Harmon Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.3.4]
b. 19 Feb 1831 d. 24 Dec 1917
11
Hannah P. Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.3.5]
b. 25 Sep 1832 d. 7 Mar 1859
11
Eliza Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.3.6]
b. 27 Jun 1834 d. 15 Dec 1907
11
Jesse Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.3.7]
b. 30 Dec 1837 d. 31 Dec 1917
10
Harvey Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.4]
b. 1 Apr 1799 d. 20 Feb 1872
Betsey M Yurann
b. 1 Jan 1800 d. 12 Jan 1839
11
Charles Chandler Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.4.1]
b. 13 Feb 1827 d. 14 Feb 1870
11
Horace Buck Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.4.2]
b. 24 Aug 1828 d. 10 Jan 1904
11
Elizabeth Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.4.3]
b. 1829
11
Lucy E. Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.4.4]
b. 7 Apr 1830 d. 4 Apr 1842
11
Betsey M. Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.4.5]
b. 7 May 1832 d. 8 May 1832
11
James Renwick Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.4.6]
b. 5 Sep 1833 d. 4 Apr 1842
11
Jason Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.4.7]
b. 27 Jul 1835 d. 23 Mar 1881
11
William N Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.4.8]
b. 22 Oct 1838 d. 6 May 1911
Electa Jenne
b. 25 Nov 1822 d. 17 Nov 1870
11
Benjamin C
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.4.9]
b. 24 Jul 1854 d. 2 May 1872
11
Jane
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.4.10]
b. 30 Sep 1855 d. 18 Oct 1918
11
Friend Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.4.11]
b. 19 Aug 1858 d. 8 Feb 1936
11
Miranda Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.4.12]
b. 15 Feb 1860 d. 26 May 1934
11
King E. Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.4.13]
b. 19 Mar 1862 d. 12 Jun 1865
10
Harriet Tupper Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.5]
b. 8 Apr 1801 d. Apr 1879
+
Ezra Martindall
10
Stephen Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.6]
b. 2 May 1803 d. 16 Apr 1851
+
Hannah Miller Hunt
b. Abt 1805
10
Mary Polly Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.7]
b. 4 May 1805 d. 13 Jun 1870
+
Hiram Chapman
b. 8 Apr 1795 d. 1867
10
Catherine Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.8]
b. 13 Jul 1807 d. 2 May 1888
James Kelsey
b. 9 Jun 1801 d. 9 Sep 1883
11
Hannah Kelsey
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.8.1]
b. 2 Mar 1829 d. 20 Nov 1905
11
Amanda Kelsey
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.8.2]
b. 24 Oct 1830 d. 1 Jun 1914
11
Eleanor Amelia Kelsey
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.8.3]
b. 5 Jul 1832 d. 9 Sep 1900
11
James Edwin Kelsey
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.8.4]
b. 5 Jul 1832 d. 27 Oct 1910
11
Julius Marcellus Kelsey
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.8.5]
b. 21 Jul 1836 d. 3 Nov 1905
11
Royal Smith Kelsey
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.8.6]
b. 7 Jun 1839 d. 24 Sep 1865
11
Mark Kelsey
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.8.7]
b. 8 Aug 1843 d. 26 Nov 1877
10
Royal Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.9]
b. 2 Jul 1809 d. 1882
+
Happeelona Peck
10
Sarah B Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.1.10]
b. 16 Dec 1810 d. 2 Oct 1887
+
Henry Barnard
+
Christene Smith
9
Priscilla Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.2]
b. 21 Oct 1769 d. 17 Apr 1860
John Curtis Waller
10
Calvin C. Waller
[1.1.2.1.5.5.9.5.2.1]
b. 6 Jun 1797 d. Jun 1864
10
Dolly Waller
[1.1.2.1.5.5.9.5.2.2]
b. 16 Oct 1799 d. 20 Jun 1800
10
Marshall Waller
[1.1.2.1.5.5.9.5.2.3]
b. 18 Mar 1801
10
Royal H Waller
[1.1.2.1.5.5.9.5.2.4]
b. 29 Nov 1802 d. 29 Sep 1866
10
Dudley C Waller
[1.1.2.1.5.5.9.5.2.5]
b. 29 Sep 1804 d. Abt 1868
+
Mrs Dudley C Waller
b. Abt 1806
10
Bushrod W Waller
[1.1.2.1.5.5.9.5.2.6]
b. 18 Oct 1806
10
Silas Waller
[1.1.2.1.5.5.9.5.2.7]
b. 1 Jan 1809 d. 2 Jun 1866
Marietta Smith
b. 1811
11
Francis Waller
[1.1.2.1.5.5.9.5.2.7.1]
b. 9 Feb 1841 d. 27 Oct 1844
11
Ellen Waller
[1.1.2.1.5.5.9.5.2.7.2]
b. 11 Sep 1845
11
Anna Buffington
[1.1.2.1.5.5.9.5.2.7.3]
b. 17 Dec 1848 d. 22 Jan 1852
11
Lilla Waller
[1.1.2.1.5.5.9.5.2.7.4]
b. 21 Dec 1851 d. 20 Jan 1929
10
Salley P Waller
[1.1.2.1.5.5.9.5.2.8]
b. 31 Oct 1810 d. 15 Aug 1874
10
John J Waller
[1.1.2.1.5.5.9.5.2.9]
b. 9 Sep 1812 d. 5 Nov 1812
+
Michael Smith
9
Joseph Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3]
b. 12 Jul 1771 d. 14 Sep 1840
Lucy Mack
b. 8 Jul 1775 d. 14 May 1856
10
Son Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.1]
b. 1797 d. 1797
10
Daughter Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.2]
b. 1797 d. 1797
10
Alvin Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.3]
b. 11 Feb 1798 d. 19 Nov 1823
10
Hyrum Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4]
b. 9 Feb 1800 d. 27 Jun 1844
Jerusha Barden
b. 15 Feb 1805 d. 13 Oct 1837
11
Lovina Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.1]
b. 16 Sep 1827 d. 8 Oct 1876
11
Mary Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.2]
b. 27 Jun 1829 d. 29 May 1832
11
John Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.3]
b. 22 Sep 1832
11
Hyrum Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.4]
b. 27 Apr 1834 d. 21 Sep 1841
11
Jerusha Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.5]
b. 13 Jan 1836 d. 27 Jun 1912
11
Sarah Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.6]
b. 2 Oct 1837 d. 6 Nov 1876
Mary Fielding
b. 21 Jul 1801 d. 21 Sep 1852
11
Joseph Fielding Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.7]
b. 13 Nov 1838 d. 19 Nov 1918
+
Levira Annette Clark Smith
b. 29 Apr 1842 d. 18 Dec 1888
Julina Lambson
b. 18 Jun 1849 d. 10 Jan 1936
12
Edward Aurthur Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.1]
b. 1 Nov 1858 d. 17 Jul 1911
12
Mercy Josephine Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.2]
b. 14 Aug 1867 d. 6 Jun 1870
12
Mary Sophronia Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.3]
b. 7 Oct 1869 d. 5 Jan 1948
12
Donnette Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.4]
b. 17 Sep 1872 d. 16 Sep 1961
12
Joseph Fielding Smith, Jr
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.5]
b. 19 Jul 1876 d. 2 Jul 1972 [
=>
]
12
David Asael Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.6]
b. 24 May 1879 bur. 9 Apr 1952
12
George Carlos Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.7]
b. 14 Oct 1881 d. 25 Feb 1931
12
Julina Clarissa Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.8]
b. 10 Feb 1884 d. 1 Aug 1923
12
Elias Wesley Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.9]
b. 21 Apr 1886 d. 28 Dec 1970
12
Emily Jane Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.10]
b. 11 Sep 1888 d. 12 Dec 1982
12
Rachel Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.11]
b. 11 Dec 1890 d. 14 Dec 1986
12
Edith Eleanor Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.12]
b. 3 Jan 1894 d. 21 May 1987
12
Marjorie Virginia Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.13]
b. 7 Dec 1906 d. 17 Nov 1994
Sarah Ellen Richards
b. 25 Aug 1850 d. 22 Mar 1915
12
Sarah Ellen Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.14]
b. 5 Feb 1869 d. 11 Feb 1869
12
Leonora Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.15]
b. 30 Jan 1871 bur. 26 Dec 1907
12
Joseph Richards Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.16]
b. 22 Feb 1873 d. 2 Oct 1954
12
Heber John Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.17]
b. 3 Jul 1876 d. 3 Mar 1877
12
Rhoda Ann Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.18]
b. 20 Jul 1878 d. 6 Jul 1879
12
Minerva Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.19]
b. 30 Apr 1880 d. 24 Jan 1958
12
Alice Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.20]
b. 27 Jul 1882 d. 29 Apr 1901
12
Willard Richards Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.21]
b. 20 Nov 1884 d. 11 Sep 1972 [
=>
]
12
Franklin Richards Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.22]
b. 12 May 1888 d. 25 Dec 1967
12
Jeanetta Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.23]
b. 25 Aug 1891 d. 27 Jan 1932
12
Asenath Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.24]
b. 28 Dec 1896 d. 3 Aug 1982
Edna Lambson
b. 3 Mar 1851
12
Hyrum Mack Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.25]
b. 21 Mar 1872 d. 23 Jan 1918
12
Alvin Fielding Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.26]
b. 7 Aug 1874 d. 4 Jan 1948
12
Alfred Jason Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.27]
b. 13 Dec 1876 d. 6 Apr 1878
12
Edna Melissa Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.28]
b. 6 Oct 1879 d. 26 Oct 1958
12
Albert Jesse Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.29]
b. 16 Sep 1881 d. 25 Aug 1883
12
Robert Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.30]
b. 12 Nov 1883 d. 4 Feb 1886
12
Emma Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.31]
b. 21 Aug 1888 d. 29 Dec 1969
12
Zina Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.32]
b. 11 Oct 1890 d. 25 Oct 1915
12
Ruth Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.33]
b. 21 Dec 1893 d. 17 Mar 1898
12
Martha Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.34]
b. 12 May 1897 d. 7 Aug 1977
Alice Ann Kimball
b. 6 Sep 1858 d. 19 Dec 1946
12
Alice May Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.35]
b. 11 Oct 1877 d. 20 Oct 1920
12
Heber Chase Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.36]
b. 19 Nov 1881 d. 29 Dec 1971
12
Charles Coulson Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.37]
b. 19 Nov 1881 d. 21 Apr 1933
12
Lucy Mack Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.38]
b. 14 Apr 1890 d. 24 Nov 1933
12
Andrew Kimball Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.39]
b. 6 Jan 1893 d. 23 Aug 1951
12
Jesse Kimball Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.40]
b. 21 May 1896 d. 21 May 1953
12
Fielding Kimball Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.41]
b. 9 Apr 1900 d. 20 Oct 1974
Mary Taylor Schwartz
b. 30 Apr 1865 d. 5 Dec 1956
12
John Schwartz Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.42]
b. 20 Aug 1888 d. 3 Aug 1889
12
Calvin Schwartz Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.43]
b. 29 May 1890
12
Samuel Schwartz Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.44]
b. 26 Oct 1892 d. 10 May 1983
12
James Schwartz Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.45]
b. 13 Nov 1894 d. 6 Nov 1950
12
Agnes Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.46]
b. 3 Nov 1897 d. 9 Mar 1966
12
Silas Schwartz Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.47]
b. 3 Jan 1900 d. 23 Apr 1983
12
Royal Grant Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.7.48]
b. 21 May 1906 d. 30 May 1971
11
Martha Ann Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.8]
b. 14 May 1841 d. 19 Oct 1923
William Jasper Harris
b. 25 Oct 1836 d. 24 Apr 1909
12
William Jasper Harris, Jr
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.8.1]
b. 4 Aug 1859 d. 23 Aug 1926
12
Joseph Albert Harris
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.8.2]
b. 19 Aug 1861 d. 28 May 1911
12
Hyrum Smith Harris
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.8.3]
b. 15 Aug 1863 d. 24 Feb 1924
12
Mary Emily Harris
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.8.4]
b. 23 Oct 1865 d. 25 Nov 1947
12
Franklin Hill Harris
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.8.5]
b. 11 Sep 1867 d. 5 Feb 1947
12
Lucy Smith Harris
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.8.6]
b. 10 Mar 1870 d. 25 Jul 1903
12
John Fielding Harris
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.8.7]
b. 28 Jun 1872 d. 28 Nov 1946
12
Mercy Ann Harris
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.8.8]
b. 30 Mar 1874 d. 23 Jan 1905
12
Zina Christine Harris
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.8.9]
b. 13 May 1876 d. 16 Mar 1958
12
Martha Artemesia Harris
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.8.10]
b. 27 Jun 1879 d. 12 Aug 1965
12
Sarah Lovina Harris
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.4.8.11]
b. 8 Dec 1882 d. 21 Apr 1961
+
Catherine Phillips
b. 1 Aug 1819 d. 26 Sep 1905
+
Mercy Rachel Fielding
b. 15 Jun 1807 d. 15 Sep 1893
10
Sophronia Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.5]
b. 17 May 1803 d. 28 Oct 1876
Calvin W Stoddard
b. 7 Sep 1801 d. 19 Nov 1836
11
Eunice Stoddard
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.5.1]
b. 22 Mar 1830 d. 24 Jun 1831
11
Mariah Stoddard
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.5.2]
b. 12 Apr 1832 d. 8 Oct 1896
+
William McCleary
b. 9 Oct 1793 d. Jun 1846
10
Samuel Harrison Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.6]
b. 13 Mar 1808 d. 30 Jul 1844
Mary Bailey
b. 20 Dec 1808 d. 25 Jan 1841
11
Susanna Bailey Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.6.1]
b. 27 Oct 1835 d. 14 Dec 1905
11
Mary Bailey Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.6.2]
b. 27 Mar 1837 d. 14 Oct 1916
11
Samuel Harrison Bailey Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.6.3]
b. 1 Aug 1838 d. 12 Jun 1914
11
Lucy Bailey Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.6.4]
b. 6 Jan 1841 d. Jan 1841
Levira Clark
b. 30 Jul 1815 d. 1 Jan 1893
11
Levira Annette Clark Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.6.5]
b. 29 Apr 1842 d. 18 Dec 1888
+
Joseph Fielding Smith
b. 13 Nov 1838 d. 19 Nov 1918
11
Lovisa Clark Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.6.6]
b. 28 Aug 1843 d. Dec 1843
11
Lucy Jane Clark Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.6.7]
b. 20 Aug 1844 d. 1844
10
Ephraim Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.7]
b. 13 Mar 1810 d. 24 Mar 1810
10
William B Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.8]
b. 13 Mar 1811 d. 13 Nov 1893
Carolina Amanda Grant
b. 22 Jan 1814 d. 22 May 1845
11
Mary Jane Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.8.1]
b. 7 Jan 1834 d. 21 Dec 1878
11
Caroline L Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.8.2]
b. Aug 1839 d. 9 Jan 1878
Roxie Ann Grant
b. 16 Mar 1825 d. 30 Mar 1900
11
Thalia Grant Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.8.3]
b. 21 Sep 1848 d. 27 Nov 1924
11
Hyrum Wallace Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.8.4]
b. 17 Aug 1850 d. 27 Jan 1935
Eliza Elise Jane Sanborn
b. 16 Apr 1827 d. 7 Mar 1889
11
William Enoch Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.8.5]
b. 23 Jul 1858 d. 13 Feb 1930
11
Edson Don Carlos Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.8.6]
b. 16 Sep 1862 d. 13 Feb 1939
11
Louise Mae "Loie " Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.8.7]
b. 8 May 1866 d. 10 May 1925
+
Rosella Goyette
b. 16 May 1830 d. 6 Apr 1923
10
Katherine Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.9]
b. 28 Jul 1813 d. 1 Feb 1900
Wilkins Jenkins Salisbury
b. 6 Jan 1809 d. 27 Nov 1853
11
Elizabeth Salisbury
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.9.1]
b. 9 Apr 1832 d. 15 Jul 1832
11
Lucy Salisbury
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.9.2]
b. 3 Oct 1834 d. 18 Oct 1892
11
Reverend Solomon Jenkins Salisbury
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.9.3]
b. 18 Sep 1835 d. 12 Jan 1927
11
Alvin Salisbury
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.9.4]
b. 7 Jun 1838 d. 21 Aug 1880
11
Reverend Don C. Salisbury
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.9.5]
b. 25 Oct 1840 d. 6 Apr 1919
11
Emma C Salisbury
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.9.6]
b. 25 Mar 1844 d. 10 Oct 1846
11
Lorin Ephraim Salisbury
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.9.7]
b. 4 May 1845 d. 18 Nov 1849
11
Frederick Vilian Salisbury
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.9.8]
b. 27 Jan 1850 d. 24 Feb 1934
+
Joseph Younger
b. 1805 d. 1900
10
Don Carlos Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.10]
b. 25 Mar 1816 d. 7 Aug 1841
Agnes Moultin Coolbrith
b. 11 Jul 1811 d. 26 Dec 1876
11
Agnes Charlotte Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.10.1]
b. 7 Aug 1836 d. 31 Jan 1873
11
Sophronia C. Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.10.2]
b. 22 Apr 1838 d. 3 Oct 1843
11
Josephine Donna "Ina Coolbrith" Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.10.3]
b. 10 Mar 1841 d. 29 Feb 1928
Robert Bruce Carsley
b. 6 Jun 1833 d. 14 Aug 1905
12
Son 1 Carsley
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.10.3.1]
b. 1860 d. 1860
12
Son 2 Carsley
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.10.3.2]
b. 1861 d. Bef 1865
10
Lucy Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.11]
b. 18 Jul 1821 d. 9 Dec 1882
Arthur Millikin
b. 9 May 1817 d. 23 Apr 1882
11
Don Carlos Smith Millikin
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.11.1]
b. 13 Oct 1843 d. 26 Nov 1932
11
Sarah M Millikin
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.11.2]
b. 13 Sep 1844 d. 23 Nov 1934
11
George William Dell Millikin
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.11.3]
b. 4 Mar 1848 d. 16 Jan 1913
11
Florence Arabella Millikin
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.11.4]
b. 23 May 1850 d. 21 Oct 1927
11
Julia Amelia Millikin
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.11.5]
b. 17 Jun 1853 d. 7 Jun 1888
11
Frances A. Millikin
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.11.6]
b. 26 Oct 1856 d. 14 Mar 1858
11
Charles Arthur Millikin
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.11.7]
b. 31 Aug 1858 d. 12 May 1884
11
Clara Irene Millikin
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.11.8]
b. 23 Aug 1861 d. 26 Mar 1948
11
Clarence Hyrum Millikin
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.11.9]
b. 26 Mar 1865 d. 5 Apr 1922
10
Joseph Smith, Jr
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.12]
b. 23 Dec 1805 d. 27 Jun 1844
Emma Hale
b. 10 Jul 1804 d. 30 Apr 1879
11
Alvin Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.12.1]
b. 15 Jun 1828 d. 15 Jun 1828
11
Joseph Murdock Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.12.2]
b. 30 Apr 1831 d. 29 Mar 1832
11
Julia Murdock Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.12.3]
b. 30 Apr 1831 d. 12 Sep 1880
+
Elisha Dixon
b. 1827 d. 1850
+
John J Middleton
b. Abt 1827 d. Abt 1869
11
Thaddeus Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.12.4]
b. 30 Apr 1831 d. 30 Apr 1831
11
Louisa Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.12.5]
b. 30 Apr 1831 d. 30 Apr 1831
11
Joseph Smith, III
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.12.6]
b. 6 Nov 1832 d. 10 Dec 1914
Emmeline Griswold
b. 12 Mar 1838 d. 25 Mar 1869
12
Emma Josepha Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.12.6.1]
b. 28 Jul 1857 d. 30 Nov 1940 [
=>
]
12
Evelyn Rebecca Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.12.6.2]
b. 25 Jan 1859 d. 30 Sep 1859
12
Carrie Lucinda Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.12.6.3]
b. 15 Sep 1861 d. 27 Apr 1944 [
=>
]
12
Zaide Viola Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.12.6.4]
b. 25 Apr 1863 d. 8 Jan 1891 [
=>
]
12
Joseph Arthur Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.12.6.5]
b. 12 Aug 1865 d. 12 Mar 1866
Bertha Madison
b. 16 Jul 1843 d. 19 Oct 1896
12
David Carlos Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.12.6.6]
b. 14 Aug 1870 d. 24 Jan 1886
12
Mary Audentia Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.12.6.7]
b. 23 Mar 1872 d. 5 May 1963
12
Frederick Madison Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.12.6.8]
b. 21 Jan 1874 d. 20 Mar 1946
12
Israel Alexander Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.12.6.9]
b. 2 Feb 1876 d. 14 Jun 1958
12
Kenneth Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.12.6.10]
b. 6 Oct 1877 d. 6 Oct 1877
12
Bertha Azubah Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.12.6.11]
b. 15 Oct 1878 d. 14 Oct 1884
12
Hale Washington Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.12.6.12]
b. 22 Feb 1881 d. 10 Jul 1956
12
Blossom Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.12.6.13]
b. 1 May 1883 d. 1 May 1883
12
Lucy Yeteve Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.12.6.14]
b. 11 Dec 1884 d. 4 Aug 1945
Ada Rachel Clark
b. 23 Jul 1871 d. 20 Oct 1915
12
Reginald Archer Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.12.6.15]
b. 26 Dec 1898 d. 20 Jun 1969
12
William Wallace Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.12.6.16]
b. 18 Nov 1900 d. 4 Aug 1989
12
Reginald Archer Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.12.6.17]
b. 8 Jan 1903 d. 28 Sep 1974
11
Frederick Granger Williams Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.12.7]
b. 20 Jun 1836 d. 13 Apr 1862
Anna Marie Jones
b. 7 Apr 1841 d. 11 Oct 1901
12
Alice Fredericka Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.12.7.1]
b. 27 Nov 1858 d. 5 Nov 1932
11
Alexander Hale Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.12.8]
b. 2 Jun 1838 d. 12 Aug 1909
Elizabeth Agnes Kendall
b. 16 Jun 1845 d. 7 May 1919
12
Frederick Alexander Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.1]
b. 19 Jan 1862 d. 25 Jun 1954 [
=>
]
12
Vida Elizabeth Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.2]
b. 16 Jan 1865 d. 3 Jan 1945 [
=>
]
12
Ina Inez Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.3]
b. 22 Nov 1866 d. 18 Aug 1945 [
=>
]
12
Emma Belle Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.4]
b. 17 Mar 1869 d. 3 May 1960 [
=>
]
12
Don Alvin Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.5]
b. 17 May 1871 d. 8 Sep 1904 [
=>
]
12
Eva Grace Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.6]
b. 1 Mar 1874 d. 26 Mar 1893 [
=>
]
12
Joseph George Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.7]
b. 7 May 1877 d. 27 Dec 1936 [
=>
]
12
Arthur Marion Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.8]
b. 8 Feb 1880 d. 21 Mar 1964 [
=>
]
12
Coral Cecil Rebekah Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.12.8.9]
b. 29 Oct 1882 d. 17 Aug 1968 [
=>
]
11
Don Carlos Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.12.9]
b. 13 Jun 1840 d. 15 Sep 1841
11
Thomas Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.12.10]
b. 6 Feb 1842 d. 6 Feb 1842
11
David Hyrum Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.12.11]
b. 17 Nov 1844 d. 29 Aug 1904
Clara Charlotte Hartshorn
b. 18 May 1851 d. 9 Aug 1926
12
Elbert Aoriul Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.3.12.11.1]
b. 8 Mar 1871 d. 15 May 1959 [
=>
]
+
Agnes Moultin Coolbrith
b. 11 Jul 1811 d. 26 Dec 1876
+
Fanny Young
b. 8 Nov 1787 d. 11 Jun 1859
+
Eliza Roxey Snow
b. 21 Jan 1804 d. 5 Dec 1887
+
Francis Ward "Fanny" Alger
b. 30 Sep 1817 d. 29 Nov 1889
+
Louisa Beaman
b. 7 Feb 1815 d. 15 May 1850
+
Helen Mar Kimball
b. 25 Aug 1828 bur. 15 Nov 1896
+
Emily Dow Partridge
b. 28 Feb 1824 d. 9 Dec 1899
+
Olive Grey Frost
b. 24 Jul 1816 d. 8 Oct 1845
+
Rhoda Richards
b. 8 Aug 1784 d. 17 Jan 1879
+
Lucy Walker
b. 30 Apr 1826 d. 1 Oct 1910
+
Sarah Ann Whitney
b. 22 Mar 1825 d. 4 Sep 1873
+
Prescinda Lothrop Huntington
b. 7 Sep 1810 d. 1 Feb 1892
+
Eliza Partridge
b. 20 Apr 1820 bur. 2 Mar 1886
+
Desdemona Wadsworth Fullmer
b. 6 Oct 1809 d. 9 Feb 1886
+
Zina Diantha Huntington
b. 31 Jan 1821 d. 28 Aug 1901
+
Mary Elizabeth Rollins
b. 9 Apr 1818 d. 17 Dec 1913
+
Martha McBride
b. 17 Mar 1805 d. 20 Nov 1901
+
Sylvia Porter Sessions
b. 31 Jul 1818 d. 12 Apr 1882
+
Patty Bartlett
b. 4 Feb 1795 d. 14 Dec 1892
+
Maria Lawrence
b. 18 Dec 1823 d. 1847
+
Sarah A Lawrence
b. 13 May 1826 d. 28 Nov 1872
9
Asahel Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4]
b. 21 May 1773 d. 21 Jul 1848
Elizabeth Shellenger
b. 1 Dec 1785 d. 14 Oct 1846
10
Elias Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.1]
b. 6 Sep 1804 d. 24 Jun 1888
Amy Jane King
b. 2 Oct 1836 d. 8 Nov 1913
11
Silas Thomas Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.1.1]
b. 4 May 1857 d. 1 May 1945
11
Jesse Moroni Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.1.2]
b. 21 Nov 1858 d. 14 Mar 1937
+
Sarah Ann Smith
b. 11 Jul 1868 d. 2 Feb 1900
11
Rebecca Jane Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.1.3]
b. 23 Sep 1860 d. 18 Jul 1923
11
Mary Alzina Knapp Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.1.4]
b. 16 May 1865 d. 20 Jan 1953
11
Martha Priscilla Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.1.5]
b. 30 May 1865 d. 18 Apr 1946
11
Amy Esther Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.1.6]
b. 11 Aug 1867 d. 21 Sep 1910
11
Angelina Adelia Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.1.7]
b. 11 Jul 1869 d. 8 Mar 1950
11
Franklin Elias Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.1.8]
b. 13 Dec 1871 d. 24 Jul 1917
11
Sarah Susannah Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.1.9]
b. 26 Mar 1873 d. 25 Apr 1952
11
Hiram Bennett Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.1.10]
b. 2 Feb 1877 d. 29 Mar 1951
Lucy Brown
b. 4 Jan 1821 d. 3 Apr 1896
11
Emily Jane Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.1.11]
b. 28 Oct 1850 d. 8 May 1878
Wilford Woodruff, Jr
b. 22 Mar 1840 d. 6 May 1921
12
Lucy Emily Woodruff
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.1.11.1]
b. 10 Jan 1869 d. 5 Nov 1937 [
=>
]
12
Wilford Smith Woodruff
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.1.11.2]
b. 25 Sep 1871 d. 26 Nov 1955
12
Elias Smith Woodruff
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.1.11.3]
b. 15 Dec 1873 d. 16 Nov 1941 [
=>
]
12
Asahel Smith Woodruff
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.1.11.4]
b. 30 Mar 1876 d. 7 Oct 1887
11
Lucy Elizabeth Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.1.12]
b. 24 Jan 1855 d. 3 Jun 1944
11
Elias Asahel Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.1.13]
b. 31 Mar 1857 d. 6 Dec 1942
11
Edith Ann Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.1.14]
b. 5 Aug 1861 d. 27 Jun 1954
10
Emily Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.2]
b. 1 Sep 1806 d. 11 Aug 1893
Samuel Pierce Hoyt
b. 21 Nov 1807 d. 12 Aug 1889
11
Cynthia Ann Hoyt
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.2.1]
b. Abt 1848
11
Hyrum Hoyt
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.2.2]
b. 1855
10
Jessie Johnson Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.3]
b. 6 Oct 1808 d. 1 Jul 1834
Sarah Ann Bennett
b. Abt 1808
11
Priscilla Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.3.1]
c. 26 Jul 1840
10
Esther Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.4]
b. 20 Sep 1810 d. 31 Oct 1856
Amos Botsford Fuller
b. 26 Mar 1810 d. 29 Mar 1853
11
Son Fuller
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.4.1]
b. 15 May 1833 d. 15 May 1833
11
Daughter Fuller
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.4.2]
b. 3 Apr 1834 d. 8 Apr 1834
11
Jesse Johnson Fuller
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.4.3]
b. 1 Jun 1835 d. 31 May 1906
11
Mary Adelia Fuller
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.4.4]
b. 31 Aug 1838 d. 5 Jan 1916
11
Luburn Livonia Fuller
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.4.5]
b. 19 Dec 1840 d. 30 Oct 1887
11
Sophina Alcesta Fuller
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.4.6]
b. 5 May 1843 d. 26 Dec 1930
George Washington Gee, Jr
b. 9 Oct 1841 d. 17 Sep 1919
12
George Washington Gee, III
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.4.6.1]
b. 8 May 1864 d. 26 Mar 1865
12
Elias Amos Gee
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.4.6.2]
b. 29 Jun 1868 d. 27 Apr 1936
12
Georgiana Gee
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.4.6.3]
b. 15 Dec 1869 d. 5 Feb 1899
12
Mary Jane Gee
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.4.6.4]
b. 8 Oct 1871 d. 16 May 1916
12
Esther Gee
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.4.6.5]
b. 29 Oct 1875 d. 22 May 1942
12
Sophina Alcesta Gee
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.4.6.6]
b. 6 Aug 1876 d. 17 May 1959 [
=>
]
12
Don Carlos Gee
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.4.6.7]
b. 20 Apr 1878 d. 11 Jan 1949
12
Bertha Victoria Gee
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.4.6.8]
b. 31 May 1880 d. 27 Dec 1930
12
Martha Electa Gee
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.4.6.9]
b. 28 Apr 1883 d. 13 May 1968
12
Adelia May Gee
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.4.6.10]
b. 14 May 1885 d. 17 Feb 1964
11
Amos Botsford Fuller
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.4.7]
b. 28 Sep 1846 d. 18 Aug 1879
11
Esther Victoria Fuller
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.4.8]
b. 13 Jan 1848 d. 4 Sep 1857
10
Mary Jane Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.5]
b. 29 Apr 1815 d. 1 Mar 1878
George Washington Gee
b. 13 Aug 1815 d. 20 Jan 1842
11
Elias Smith Gee
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.5.1]
b. 30 May 1838 d. 10 Aug 1855
11
George Washington Gee, Jr
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.5.2]
b. 9 Oct 1841 d. 17 Sep 1919
Sophina Alcesta Fuller
b. 5 May 1843 d. 26 Dec 1930
12
George Washington Gee, III
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.5.2.1]
b. 8 May 1864 d. 26 Mar 1865
12
Elias Amos Gee
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.5.2.2]
b. 29 Jun 1868 d. 27 Apr 1936
12
Georgiana Gee
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.5.2.3]
b. 15 Dec 1869 d. 5 Feb 1899
12
Mary Jane Gee
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.5.2.4]
b. 8 Oct 1871 d. 16 May 1916
12
Esther Gee
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.5.2.5]
b. 29 Oct 1875 d. 22 May 1942
12
Sophina Alcesta Gee
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.5.2.6]
b. 6 Aug 1876 d. 17 May 1959 [
=>
]
12
Don Carlos Gee
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.5.2.7]
b. 20 Apr 1878 d. 11 Jan 1949
12
Bertha Victoria Gee
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.5.2.8]
b. 31 May 1880 d. 27 Dec 1930
12
Martha Electa Gee
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.5.2.9]
b. 28 Apr 1883 d. 13 May 1968
12
Adelia May Gee
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.5.2.10]
b. 14 May 1885 d. 17 Feb 1964
10
Julia Priscilla Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.6]
b. 4 Mar 1815 d. 14 Aug 1906
Moses Martin
b. 1 Jun 1812 d. 5 May 1899
11
Julia Priscilla Martin
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.6.1]
b. 1 Aug 1838 d. 14 Jan 1873
11
Napoleon J Martin
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.6.2]
b. 1841
11
Rosella A Martin
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.6.3]
b. 18 Aug 1844 d. 13 Sep 1909
11
Hiram Martin
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.6.4]
b. 1 Aug 1847 d. Sep 1882
11
Joseph Martin
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.6.5]
b. Abt 1850
11
Emma Cecelia Martin
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.6.6]
b. Aug 1850 d. Jul 1882
11
Ada Martin
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.6.7]
b. 1854
10
Silas Schellinger Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.7]
b. 6 Jun 1822 d. 11 Jun 1892
Elizabeth Orton
b. 1 Jun 1826 d. 27 Nov 1902
11
Silas Marion Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.7.1]
b. 17 Apr 1845 d. 20 Oct 1898
11
Julia Elizabeth Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.7.2]
b. 29 Jul 1848 d. 28 Oct 1878
Melvin Ross
b. 24 Sep 1842 d. 29 Nov 1920
12
Sarah Lovina Ross
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.7.2.1]
b. 27 Mar 1863 d. 10 Jan 1919
12
Francis Marion Ross
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.7.2.2]
b. 18 Apr 1866 d. 28 Mar 1949
12
Don Carlos Ross
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.7.2.3]
b. 18 Jul 1867 d. 27 Oct 1918
12
James Melvin Ross
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.7.2.4]
b. 16 Jan 1871 d. 25 Jul 1937
12
Mary Esther Ross
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.7.2.5]
b. 14 Mar 1873 d. 2 Apr 1950 [
=>
]
12
Silas Asahel Ross
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.7.2.6]
b. 17 Jun 1875 d. 1895
12
Emma Ross
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.7.2.7]
b. 7 Mar 1878 d. 1881
11
Frederick Asael Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.7.3]
b. 24 Jan 1850 d. 1850
11
Mary Jane Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.7.4]
b. 17 Jun 1853 d. 5 Jan 1917
John Thompson Rowley
b. 7 Nov 1847 d. 31 Jan 1925
12
John Henry Rowley
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.7.4.1]
b. 10 Feb 1882 d. 14 Aug 1928
12
David Smith Rowley
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.7.4.2]
b. 29 Aug 1883 d. 26 Jan 1955
12
Silas Rowley
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.7.4.3]
b. 28 Oct 1885 d. 11 Oct 1949
12
Mary Ann Rowley
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.7.4.4]
b. 5 Dec 1887 d. 20 Jul 1968
12
Franklin Irvin Rowley
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.7.4.5]
b. 1 Jan 1890 d. 18 Jun 1951
12
Ephraim Rowley
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.7.4.6]
b. 14 Oct 1893 bur. 14 Oct 1893
12
George Albert Rowley
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.7.4.7]
b. 27 Nov 1894 d. 20 Jul 1976
11
Prince Henry Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.7.5]
b. 20 Oct 1858 d. 28 Nov 1922
11
Franklin D Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.7.6]
b. 29 Dec 1862 d. 16 Nov 1924
11
Vienna Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.7.7]
b. 16 Jun 1864 d. 17 Aug 1874
11
Martha Eliza Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.7.8]
b. 8 Oct 1869 d. 19 Jul 1956
Sarah Orton
b. 12 May 1830 d. 11 Dec 1912
11
Prince William Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.7.9]
b. 2 Aug 1859 d. 16 Nov 1909
11
Alexander Randolph Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.7.10]
b. 23 Dec 1861 d. 10 Sep 1865
11
David Hyrum Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.7.11]
b. 23 Dec 1863 d. 11 Mar 1865
11
Elias Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.7.12]
b. 16 May 1867 d. 18 Sep 1942
11
Sarah Esther Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.7.13]
b. 4 Nov 1869 d. 7 Nov 1869
11
Alonzo Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.7.14]
b. 5 Apr 1871 d. 24 Jan 1916
Ova Elizabeth Collins
b. 8 Aug 1879 d. 3 Jun 1960
12
Sarah Ethel Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.7.14.1]
b. 22 May 1901 d. 8 Mar 1997
12
Rachel Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.7.14.2]
b. 25 Aug 1902 d. 12 May 1964 [
=>
]
12
Fred Alonzo Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.7.14.3]
b. 13 Dec 1903 d. 1 Sep 1929
12
Lawrence Owen Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.7.14.4]
b. 19 Sep 1905 d. 21 Feb 1988
12
Edith Elizabeth Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.7.14.5]
b. 25 Jan 1907 d. 31 Oct 1939 [
=>
]
12
Arnold Elias Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.7.14.6]
b. 31 Oct 1910 d. 23 Jan 1976 [
=>
]
12
Grace Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.7.14.7]
b. 23 Feb 1913 d. 23 Nov 1997 [
=>
]
10
Martha Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.8]
b. 9 Jun 1817 d. 12 Oct 1902
Hiram Bell Bennett
b. 1 Mar 1823 d. 17 Aug 1912
11
Henry Bell Bennett
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.8.1]
b. Jun 1846 d. Jun 1846
11
Hyrum William Asahel Bennett
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.8.2]
b. 22 Nov 1848 d. 9 Jan 1849
11
Martha Eliza Bennett
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.8.3]
b. 24 Jan 1849 d. 6 May 1924
Silas Sanford Smith, Jr
b. 26 Oct 1830 d. 11 Oct 1910
12
Sarah Ann Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.1]
b. 11 Jul 1868 d. 2 Feb 1900
12
Martha Eliza Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.2]
b. 17 Mar 1870 d. 7 Jan 1957 [
=>
]
12
Curtis Bennett Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.3]
b. 23 Oct 1871 d. 28 Nov 1942
12
Elias Austin Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.4]
b. 4 Mar 1874 d. 27 Jun 1925 [
=>
]
12
Emma Jane Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.5]
b. 4 Apr 1876 d. 16 Jan 1951 [
=>
]
12
George Essex Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.6]
b. 24 Sep 1878 d. 26 May 1949 [
=>
]
12
Erastus Snow Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.7]
b. 18 Aug 1881 d. 16 Sep 1890
12
Hyrum Asahel Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.8]
b. 15 Sep 1883 d. 16 Jul 1941 [
=>
]
12
Lucy Edith Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.9]
b. 12 Aug 1886 d. 6 Jan 1963 [
=>
]
12
Joseph Frances Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.10]
b. 7 Apr 1889 d. 14 Feb 1920 [
=>
]
12
Clara Estella Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.11]
b. 4 Aug 1891 d. 10 May 1992
12
Verlie Dorcas Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.8.3.12]
b. 14 Oct 1894 d. 23 Dec 1894
11
Ezra Melanthorn Bennett
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.8.4]
b. 20 Oct 1851 d. 25 Aug 1852
11
Emily Jane Bennett
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.8.5]
b. 17 Jan 1854 d. 4 May 1903
John Aikens Smith
b. 19 Mar 1854 d. 9 Jan 1923
12
Emily Jane Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.8.5.1]
b. 5 May 1878 d. 21 Feb 1958 [
=>
]
12
Sarah Ann Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.8.5.2]
b. 23 Apr 1883 d. 22 Feb 1969 [
=>
]
12
Mary Hortense Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.8.5.3]
b. 19 Dec 1884 d. 8 Jun 1885
12
Martha Eliza Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.8.5.4]
b. 23 Aug 1886 d. 2 Apr 1980 [
=>
]
12
John Aikens Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.8.5.5]
b. 5 Oct 1888 d. 4 Apr 1970 [
=>
]
12
Lucy Elizabeth Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.8.5.6]
b. 24 May 1893 d. 23 Oct 1944
11
Elizabeth Emma Bennett
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.8.6]
b. 2 Jul 1856 d. 26 Feb 1940
Joseph Henry Fisher
b. 18 Oct 1856 d. 21 Nov 1940
12
Zina Elizabeth Fisher
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.8.6.1]
b. 6 Nov 1880 d. 14 Feb 1890
12
Martha Hannah Lees Fisher
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.8.6.2]
b. 19 Feb 1882 d. 23 May 1958 [
=>
]
12
Mary Emily Fisher
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.8.6.3]
b. 25 Oct 1883 d. 18 Feb 1890
12
Joseph Lees Fisher
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.8.6.4]
b. 5 Oct 1885 d. 14 Feb 1890
12
Albert Hyrum Fisher
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.8.6.5]
b. 28 Dec 1888 d. 10 Jul 1973 [
=>
]
12
Angie Celestine Fisher
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.8.6.6]
b. 2 May 1893 d. 25 Nov 1971 [
=>
]
12
James Clyde Fisher
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.8.6.7]
b. 5 Jun 1896 d. 19 Nov 1977
12
Cecil Neil Fisher
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.8.6.8]
b. 8 Jul 1898 d. 2 Oct 1983 [
=>
]
11
Elias Austin Bennett
[1.1.2.1.5.5.9.5.4.8.7]
b. 26 Jan 1858 d. 1 May 1861
+
Jane Smith
b. 1775
9
Mary Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.5]
b. 4 Jun 1775 d. 24 May 1844
Isaac Pierce
b. 11 Oct 1773 d. 9 Nov 1847
10
Eunice Pierce
[1.1.2.1.5.5.9.5.5.1]
b. 29 Apr 1799 d. 9 Jun 1803
10
Laura Pierce
[1.1.2.1.5.5.9.5.5.2]
b. 12 Nov 1801 d. 1803
10
Miranda Pierce
[1.1.2.1.5.5.9.5.5.3]
b. 17 Jun 1803 d. 16 Sep 1831
10
Horace Pierce
[1.1.2.1.5.5.9.5.5.4]
b. 8 Jun 1805 d. 20 May 1877
10
John S. Pierce
[1.1.2.1.5.5.9.5.5.5]
b. 6 Jun 1807 d. 3 Apr 1854
10
Susan Pierce
[1.1.2.1.5.5.9.5.5.6]
b. 20 Jun 1809 d. 4 Apr 1855
10
Mary Pierce
[1.1.2.1.5.5.9.5.5.7]
b. 25 Apr 1811
10
Elisabeth Ann Pierce
[1.1.2.1.5.5.9.5.5.8]
b. 2 Sep 1817 d. 16 May 1855
+
Joseph Brimhall
b. 1771
+
Charles Smith
b. 1772
9
Samuel Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.6]
b. 15 Sep 1777 d. 1 Apr 1830
Frances Wilcox
b. 1780
10
Charles Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.6.1]
b. 16 Apr 1817
10
Laura Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.6.2]
b. 1 Mar 1819
10
Horace Jay Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.6.3]
b. 12 Jul 1821
10
Sarah Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.6.4]
b. 11 Jun 1824
10
Elizabeth Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.6.5]
b. 16 Jul 1826
9
Silas Sanford Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7]
b. 1 Oct 1779 d. 13 Sep 1839
Ruth Steven
b. 1782 d. 10 Jan 1864
10
Charles Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.1]
b. 11 Nov 1806 d. 7 May 1809
10
Charity Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.2]
b. 1 Apr 1808 d. 2 Jun 1888
+
Richard Smith
b. 1808
10
Curtis Stevens Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.3]
b. 29 Oct 1809 d. 23 Sep 1861
Celia Euphrasia Ross
b. 1829 d. 28 Jun 1857
11
Ezra Ross Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.3.1]
b. 24 Jul 1852 d. 17 May 1853
11
William Curtis Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.3.2]
b. 14 Apr 1857 d. 1 Mar 1945
10
Samuel Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.4]
b. 3 Oct 1811 d. 7 Mar 1826
10
Stephen Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.5]
b. 8 Jan 1815 d. 20 Feb 1891
10
Susan Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.6]
b. 19 Oct 1817 d. 20 Nov 1846
10
Asahel Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.7]
b. 12 Oct 1819 d. 15 May 1834
Mary Aikens
b. 13 Aug 1797 d. 27 Apr 1877
10
Silas Sanford Smith, Jr
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8]
b. 26 Oct 1830 d. 11 Oct 1910
Martha Eliza Bennett
b. 24 Jan 1849 d. 6 May 1924
11
Sarah Ann Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.1]
b. 11 Jul 1868 d. 2 Feb 1900
+
Jesse Moroni Smith
b. 21 Nov 1858 d. 14 Mar 1937
+
John Cranmer Dalton
b. 9 Jan 1857 d. 31 Aug 1906
11
Martha Eliza Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.2]
b. 17 Mar 1870 d. 7 Jan 1957
Thales Hastings Haskell, Jr
b. 20 Oct 1868 d. 23 Apr 1952
12
Green Dwight Haskell
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.2.1]
b. 8 Dec 1899 d. 25 Apr 1975 [
=>
]
12
Mark Smith Haskell
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.2.2]
b. 21 Apr 1901 d. 21 Feb 1958
12
Annie Haskell
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.2.3]
b. 10 Sep 1902 d. 11 Feb 1993 [
=>
]
12
Thales Edward Haskell
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.2.4]
b. 14 Oct 1904 d. 22 Dec 1982 [
=>
]
12
Hattie Haskell
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.2.5]
b. 3 Oct 1907 d. 1 Jan 1963
11
Curtis Bennett Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.3]
b. 23 Oct 1871 d. 28 Nov 1942
+
Ursula Pearl Harrison
b. 25 Jul 1879 d. 10 Nov 1960
11
Elias Austin Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.4]
b. 4 Mar 1874 d. 27 Jun 1925
Jessie Arlettia Block
b. 20 Feb 1879 d. 22 Apr 1958
12
Eva Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.4.1]
b. 8 Jun 1899 d. 22 Aug 1979 [
=>
]
12
Austin Block Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.4.2]
b. 26 Dec 1900 d. 1 Aug 1976 [
=>
]
12
Elias Penn Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.4.3]
b. 1 Oct 1902 d. 1 Feb 1976
12
Mack Bennett Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.4.4]
b. 23 Nov 1905 d. 1975 [
=>
]
12
Rex Poulson Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.4.5]
b. 3 Nov 1910 d. 22 Mar 1925
12
Amy Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.4.6]
b. 26 Sep 1913 d. 20 Mar 1994 [
=>
]
11
Emma Jane Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.5]
b. 4 Apr 1876 d. 16 Jan 1951
Edwin Cleveland Dibble
b. 1 Sep 1869 d. 28 Jan 1947
12
Edwin Smith Dibble
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.5.1]
b. 5 Dec 1901 d. 12 Sep 2003
12
George Smith Dibble
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.5.2]
b. 29 Mar 1904 d. 1 Jun 1992
12
Joseph Smith Dibble
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.5.3]
b. 6 Jun 1907 d. 17 Sep 1973 [
=>
]
12
Asael Smith Dibble
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.5.4]
b. 31 Jul 1910 d. 16 Dec 2000 [
=>
]
12
Verlie Dibble
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.5.5]
b. 25 Nov 1917 d. 19 Sep 1985
11
George Essex Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.6]
b. 24 Sep 1878 d. 26 May 1949
Vista May Rogers
b. 27 Aug 1880 d. 27 Jun 1954
12
May Rhue Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.6.1]
b. 8 Nov 1902 d. 6 Jul 1989
12
George Essex Smith, Jr
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.6.2]
b. 5 Aug 1904 d. 20 Jan 1985
12
Margaret Eliza Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.6.3]
b. 17 May 1906 d. 6 May 1996
12
Silas Bennett Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.6.4]
b. 16 Jan 1908 d. 27 Jan 1908
12
Sanford Snow Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.6.5]
b. 20 Feb 1911 d. 6 Dec 1928
12
Martha Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.6.6]
b. 20 Aug 1915 d. 21 Nov 1915
12
Milton Ralph Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.6.7]
b. 26 Oct 1918 d. 13 Aug 1986
11
Erastus Snow Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.7]
b. 18 Aug 1881 d. 16 Sep 1890
11
Hyrum Asahel Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.8]
b. 15 Sep 1883 d. 16 Jul 1941
Rebecca Pearl Hodson
b. 26 Oct 1883 d. 17 Oct 1965
12
Inez Myrtle Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.8.1]
b. 17 Nov 1905 d. 1 Aug 1994
12
Asahel Earl Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.8.2]
b. 29 Mar 1910 d. 3 Jan 1969 [
=>
]
12
Annie Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.8.3]
b. 24 Nov 1912 d. 23 Feb 1913
12
Fay Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.8.4]
b. 18 Feb 1915 d. 9 Jan 2000
12
Donald Hodson Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.8.5]
b. 19 May 1923 d. 12 Aug 1943
11
Lucy Edith Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.9]
b. 12 Aug 1886 d. 6 Jan 1963
David DuBois Dibble
b. 13 Sep 1876 d. 24 Apr 1975
12
Frances Dibble
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.9.1]
b. 18 Dec 1923 d. 16 Sep 1990 [
=>
]
12
David Smith Dibble
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.9.2]
b. 2 Apr 1928 d. 27 Dec 1993 [
=>
]
11
Joseph Frances Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.10]
b. 7 Apr 1889 d. 14 Feb 1920
Lavinia Ann Webster
b. 2 Mar 1890 d. 29 Nov 1962
12
Verlie W Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.10.1]
b. 14 Oct 1915 d. 17 Feb 2001 [
=>
]
12
Francis Bennett Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.10.2]
b. 29 Oct 1917 d. 12 Apr 1978
12
Arthur Agle Millecan
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.10.3]
b. 30 Jul 1922 d. 10 Apr 2003 [
=>
]
11
Clara Estella Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.11]
b. 4 Aug 1891 d. 10 May 1992
11
Verlie Dorcas Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.12]
b. 14 Oct 1894 d. 23 Dec 1894
Clarinda Rich
b. 10 Jan 1835 d. 18 Mar 1864
11
Silas Sanford Smith, Jr
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.13]
b. 10 Jul 1853 d. 19 Jan 1911
11
Jesse Joel Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.14]
b. 4 Nov 1857 d. 12 Sep 1905
11
Leonora Abigail Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.15]
b. 22 Oct 1859 d. 26 Sep 1863
11
Stephen Augustus Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.16]
b. 1 Nov 1861 d. 21 Oct 1939
11
Ella Clarinda Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.17]
b. 9 Mar 1864 d. 2 Jun 1913
Sally Ann Ricks
b. 28 Dec 1832 d. 30 Jun 1864
11
John Aikens Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.18]
b. 19 Mar 1854 d. 9 Jan 1923
Emily Jane Bennett
b. 17 Jan 1854 d. 4 May 1903
12
Emily Jane Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.18.1]
b. 5 May 1878 d. 21 Feb 1958 [
=>
]
12
Sarah Ann Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.18.2]
b. 23 Apr 1883 d. 22 Feb 1969 [
=>
]
12
Mary Hortense Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.18.3]
b. 19 Dec 1884 d. 8 Jun 1885
12
Martha Eliza Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.18.4]
b. 23 Aug 1886 d. 2 Apr 1980 [
=>
]
12
John Aikens Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.18.5]
b. 5 Oct 1888 d. 4 Apr 1970 [
=>
]
12
Lucy Elizabeth Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.18.6]
b. 24 May 1893 d. 23 Oct 1944
11
Mary Eleanor Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.19]
b. 26 Sep 1857 d. 25 Nov 1888
11
Hortense Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.20]
b. 14 Oct 1859 d. 8 Sep 1945
11
Albert Ricks Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.21]
b. 1 Apr 1862 d. 17 May 1905
11
Hyrum Barton Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.8.22]
b. 16 Jun 1864 d. 9 Aug 1864
10
John Aikens Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.9]
b. 6 Jul 1832 d. 27 Nov 1838
10
Jesse Nathaniel Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10]
b. 2 Dec 1834 d. 5 Jun 1906
Augusta Maria Outzen
b. 14 Jan 1854 d. 26 Apr 1932
11
Georgianna Bathsheba Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.1]
b. 16 Aug 1870 d. 14 May 1946
11
Augusta Gerhardina "Dina" Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.2]
b. 14 Jul 1872 d. 9 Jan 1940
11
Robert Christian Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.3]
b. 27 Nov 1874 d. 9 Apr 1920
11
Martha Amelia Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.4]
b. 17 Jul 1877 d. 10 Aug 1931
James Madison Flake
b. 8 Nov 1859 d. 4 Feb 1946
12
Donald Christian Flake
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.4.1]
b. 24 Oct 1897 d. 4 Jan 1979
12
Augusta Flake
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.4.2]
b. 4 Mar 1899 d. 1 Jun 1993
12
Silas Eugene Flake
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.4.3]
b. 9 Sep 1900 d. 19 Dec 1983
12
Virgil Maeser Flake
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.4.4]
b. 24 Feb 1902 d. 19 Jan 1966
12
Joseph Marion Flake
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.4.5]
b. 8 Oct 1903 d. 24 Jan 1982
12
Thelma Flake
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.4.6]
b. 3 Jul 1905 d. 7 Dec 1923
12
Bruce Merlin Flake
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.4.7]
b. 27 Jan 1907 d. 10 May 1971
12
Vernon Smith Flake
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.4.8]
b. 23 Dec 1908 d. 15 Sep 1965
12
Mary Flake
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.4.9]
b. 10 Aug 1910 d. 27 Aug 1910
12
Anna Flake
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.4.10]
b. 24 Sep 1911 d. 20 Mar 2000
12
Ruth Flake
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.4.11]
b. 23 Nov 1913 d. 6 Jun 1975
12
Vincent Madison Flake
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.4.12]
b. 19 Jul 1915 d. 19 Aug 1988
12
Aften Flake
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.4.13]
b. 8 Aug 1916 d. 1 Oct 2008
12
Fost Wilson Flake
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.4.14]
b. 12 Mar 1918 d. 31 Aug 1997
11
Asahel Henry Smith, Sr
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.5]
b. 5 Dec 1880 d. 7 Sep 1947
11
Anna Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.6]
b. 6 Aug 1883 d. 8 Oct 1910
11
Rebecca Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.7]
b. 23 Oct 1886 d. 3 Nov 1960
11
Rachel Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.8]
b. 1 Jan 1889 d. 13 Jul 1940
11
Sophronia Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.9]
b. 8 Apr 1892 d. 11 Oct 1953
11
Natalia Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.10]
b. 3 Apr 1894 d. 2 Jun 1978
11
Millie Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.11]
b. 25 Dec 1897 d. 3 Oct 1931
Emma Seraphine West
b. 3 Jan 1836 d. 15 Oct 1910
11
Emma Seraphine Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.12]
b. 12 Aug 1853 d. 29 Dec 1909
11
Mary Josephine Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.13]
b. 23 Jan 1855 d. 17 Dec 1894
11
Hannah Daphne Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.14]
b. 22 Mar 1857 d. 10 May 1937
11
Eliza Snow Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.15]
b. 23 Feb 1859 d. 27 Dec 1927
11
Jesse Nathaniel Smith, Jr
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.16]
b. 16 May 1861 d. 13 Jul 1912
11
Sarah Elizabeth Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.17]
b. 2 Feb 1866 d. 15 Sep 1892
11
Silas Derryfield Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.18]
b. 9 Sep 1867 d. 26 Feb 1956
11
John Walter Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.19]
b. 10 Jun 1871 d. 7 May 1936
11
Samuel Francis Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.20]
b. 21 Nov 1873 d. 24 Jan 1954
Margaret Fletcher West
b. 22 May 1838 d. 1 Feb 1864
11
Adelaide Margaret Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.21]
b. 13 Feb 1857 d. 29 Oct 1927
11
Joseph West Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.22]
b. 6 Sep 1859 d. 22 Dec 1944
Janet Mauretta Johnson
b. 17 Dec 1848 d. 21 May 1933
11
Susan Janet Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.23]
b. 15 Sep 1868 d. 15 Dec 1960
Heber Jarvis
b. 14 Oct 1860 d. 8 Oct 1953
12
Heber Jarvis, Jr
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.23.1]
b. 15 Apr 1885 d. 26 Mar 1886
12
Jesse Rulon Jarvis
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.23.2]
b. 13 Jun 1886 d. 10 Jun 1960 [
=>
]
12
Maude Jarvis
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.23.3]
b. 26 Jan 1888 d. 14 Mar 1974
12
George Jarvis
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.23.4]
b. 21 Mar 1889 d. 28 Aug 1981
12
Janet Jarvis
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.23.5]
b. 10 Feb 1891 d. 20 Oct 1944
12
Annie Jarvis
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.23.6]
b. 22 Apr 1892 d. 5 Apr 1893
12
Joseph Smith Jarvis
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.23.7]
b. 6 Mar 1894 d. 12 Jun 1989
12
Pearl Jarvis
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.23.8]
b. 7 Aug 1896 d. 12 Dec 1983
12
William Prior Jarvis
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.23.9]
b. 22 Sep 1898 d. 17 Mar 1973
12
Susie Jarvis
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.23.10]
b. 1 May 1901 d. 18 May 1929
12
Thomas Earl Jarvis
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.23.11]
b. 25 Apr 1903 d. 17 Apr 1906
12
Silas Fielding Jarvis
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.23.12]
b. 28 Feb 1905 d. 19 Oct 1983
12
Margaret Jarvis
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.23.13]
b. 1 Oct 1906 d. 19 Mar 1994
12
Ethel Jarvis
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.23.14]
b. 18 Oct 1908 d. 13 Sep 2006
12
Rudger LaVerl Jarvis
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.23.15]
b. 15 May 1911 d. 29 Jun 2002
11
Ellen Mauretta Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.24]
b. 20 Sep 1871 d. 1 Aug 1872
11
Sariah Anna Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.25]
b. 21 Feb 1873 d. 26 Dec 1922
11
Agnes Maud Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.26]
b. 11 Jul 1874 d. 7 Oct 1878
11
Julia Johnson Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.27]
b. 20 Oct 1875 d. 27 Apr 1956
11
Priscilla Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.28]
b. 10 May 1877 d. 17 Jan 1954
11
Editha Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.29]
b. 8 Sep 1878 d. 28 Jul 1931
11
Lucy Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.30]
b. 24 Jun 1880 d. 15 Nov 1951
William Howard Shumway
b. 20 Jul 1877 d. 20 Jun 1945
12
Donnetta Shumway
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.30.1]
b. 27 Oct 1899 d. 9 Jan 1955
12
Howard Burton Shumway
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.30.2]
b. 5 Mar 1901 d. 21 Jul 1933
12
Priscilla Shumway
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.30.3]
b. 2 Mar 1903 d. 15 Jan 1992
12
Kenneth Smith Shumway
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.30.4]
b. 13 Feb 1905 d. 10 Oct 1972
12
Charles Richard Shumway
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.30.5]
b. 12 Aug 1907 d. 17 Dec 1990
12
Elizabeth Shumway
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.30.6]
b. 25 Jan 1910 d. 6 Aug 1993
12
Jesse N Smith Shumway
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.30.7]
b. 18 Mar 1912 d. 14 Dec 2000 [
=>
]
12
Janet Smith Shumway
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.30.8]
b. 30 Jul 1914 d. 22 Dec 1982
12
Lucy Shumway
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.30.9]
b. 10 Oct 1917 d. 28 Nov 1998
12
Margaret Shumway
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.30.10]
b. 10 Feb 1920 d. 2 Feb 2013
12
Julia Rosalind Shumway
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.30.11]
b. 20 Apr 1922 d. 22 Aug 2011
12
Nephi Grant Shumway
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.30.12]
b. 8 Mar 1925 d. 15 Oct 1944
11
Margaret Fife Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.31]
b. 6 Sep 1882 d. 28 Mar 1969
11
Ruth Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.32]
b. 17 Mar 1884 d. 31 Dec 1956
11
Esther Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.33]
b. 26 Oct 1887 d. 8 Dec 1975
11
Elias Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.34]
b. 1 Aug 1889 d. 23 Dec 1961
11
Leah Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.35]
b. 13 Aug 1891 d. 17 Feb 1976
Emma Ellen Larson
b. 6 Apr 1863 d. 2 Jun 1943
11
Hyrum Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.36]
b. 15 Dec 1882 d. 22 Mar 1971
11
Caroline Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.37]
b. 19 Nov 1884 d. 19 Jan 1924
11
Don Carlos Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.38]
b. 26 Sep 1886 d. 28 Oct 1967
11
Lorana Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.39]
b. 29 Nov 1888 d. 25 Apr 1979
11
Lehi Larson Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.40]
b. 19 Mar 1891 d. 28 Oct 1918
11
George Albert Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.41]
b. 7 May 1893 d. 31 Jan 1965
11
Aikens Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.42]
b. 29 Jul 1899 d. 17 Jul 1960
11
Myrtle Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.43]
b. 25 Oct 1901 d. 10 Jan 1977
11
Matthias Foss Cowley Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.7.10.44]
b. 1 Oct 1905 d. 5 Feb 1990
9
Patriarch John Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.8]
b. 16 Jul 1781 d. 23 May 1854
Clarissa Loomis Lyman
b. 27 Jun 1790 d. 14 Feb 1854
10
Daughter Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.1]
b. 9 May 1816 d. 9 May 1816
10
George Albert Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.2]
b. 26 Jun 1817 d. 1 Sep 1875
Bathsheba Wilson Bigler
b. 3 May 1822 d. 20 Sep 1910
11
George Albert Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.2.1]
b. 7 Jul 1842 bur. 8 Jan 1876
11
Son Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.2.2]
b. Abt 1844
11
Bathsheba Kate Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.2.3]
b. 14 Aug 1844 d. 22 Dec 1920
11
Daughter Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.2.4]
b. Abt 1846
11
John Henry Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.2.5]
b. 4 Apr 1847 d. 4 Apr 1847
Nancy A Clement
b. 31 Oct 1815 d. 26 Mar 1847
11
Lydia Crane
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.2.6]
b. 1800 d. Oct 1827
11
Nancy Alida Crane
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.2.7]
b. 20 Mar 1807 d. Dec 1882
11
Nancy Adelia Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.2.8]
b. 20 Mar 1846 d. 17 Apr 1847
11
Ellen Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.2.9]
b. Dec 1846 d. Apr 1847
Lucy Messerve Smith
b. 9 Feb 1817 d. 5 Oct 1892
11
Don Carlos Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.2.10]
b. 11 Aug 1846 d. 21 Jul 1847
11
Joel Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.2.11]
b. 6 Aug 1850 d. 6 Aug 1850
Zilpha Stark
b. 3 Jul 1818 d. 19 Sep 1887
11
Zilpha Adelade Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.2.12]
b. 12 Mar 1846 d. 12 May 1846
11
Joseph Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.2.13]
b. 2 Jan 1850 d. 8 Oct 1850
11
Mary Amelia Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.2.14]
b. 14 Feb 1852 d. 20 Mar 1915
Sarah Ann Libby
b. 7 May 1818 d. 12 Jun 1851
11
John Henry Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.2.15]
b. 18 Sep 1848 d. 13 Oct 1911
Sarah Farr
b. 30 Oct 1849 d. 4 Feb 1921
12
John Henry Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.2.15.1]
b. 22 Feb 1868 d. 20 Sep 1868
12
George Albert Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.2.15.2]
b. 4 Apr 1870 d. 4 Apr 1951 [
=>
]
12
Lorin Farr Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.2.15.3]
b. 22 Apr 1872 d. 9 Jul 1872
12
Don Carlos Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.2.15.4]
b. 18 Mar 1874 d. 5 Jan 1927
12
Ezra Chase Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.2.15.5]
b. 21 Sep 1876 d. 28 Apr 1951
12
Charles Warren Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.2.15.6]
b. 3 Aug 1879 d. 7 Dec 1879
12
Winslow Farr Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.2.15.7]
b. 19 Jan 1881 d. 25 Dec 1966
12
Nathaniel Libby Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.2.15.8]
b. 19 Jun 1883 d. 1 Jul 1935
12
Joseph Harmon Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.2.15.9]
b. 17 Dec 1884 d. 23 May 1942
12
Tirzah Priscilla Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.2.15.10]
b. 11 Jun 1887 d. 12 Jun 1951
12
Elsie Louise Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.2.15.11]
b. 19 Oct 1891 d. 26 Dec 1956
Josephine Groesbeck
b. 13 Oct 1857 d. 1 Nov 1948
12
Sarah Ann Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.2.15.12]
b. 2 Oct 1878 d. 11 Feb 1938
12
Nicholas Groesbeck Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.2.15.13]
b. 20 Jun 1881 d. 27 Oct 1945
12
Joseph Harmon Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.2.15.14]
b. 17 Dec 1884 d. 23 May 1942
12
Lucy Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.2.15.15]
b. 24 Dec 1887 d. 7 Sep 1900
12
Elizabeth Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.2.15.16]
b. 30 Jan 1890 d. 9 Mar 1973
12
Glen Grosbeck Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.2.15.17]
b. 19 Sep 1893 d. 19 Jun 1970
12
Arzella Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.2.15.18]
b. 5 Nov 1895 d. 4 Jan 1969
12
Josephine Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.2.15.19]
b. 3 Jan 1898 d. 12 Aug 1973
Hannah Maria Libby
b. 29 Jun 1828 d. 21 Sep 1906
11
Charles Warren Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.2.16]
b. 16 Jan 1849 d. 25 Jan 1903
11
Sarah Maria Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.2.17]
b. 1 Jan 1856 d. 16 Jan 1912
11
Eunice Albertine Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.2.18]
b. 6 Mar 1860 d. 4 Oct 1861
11
George Albert Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.2.19]
b. 7 Apr 1862 d. 28 Oct 1863
11
Grace Libby Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.2.20]
b. 14 May 1865 d. 27 Feb 1939
Susan Elizabeth West
b. 4 Dec 1833 d. 6 Jul 1935
11
Clarissa West Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.2.21]
b. 21 Apr 1859 d. 8 Mar 1930
11
Margaret West Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.2.22]
b. 6 Dec 1862 d. 18 Jun 1913
11
Elizabeth Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.2.23]
b. 28 Sep 1866 d. 6 Jan 1921
11
Priscilla Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.2.24]
b. 11 Jun 1869 d. 3 Nov 1907
11
Emma Pearl Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.2.25]
b. 19 Apr 1871 d. 6 Oct 1905
10
Caroline Clara Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.3]
b. 6 Jun 1820 d. 8 Jan 1895
Thomas Callister
b. 8 Jul 1821 d. 1 Dec 1880
11
Thomas Callister
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.3.1]
b. 13 Sep 1846 d. 8 May 1847
11
Clarissa Callister
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.3.2]
b. 28 May 1848 d. 4 Oct 1848
11
Clara Caroline Callister
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.3.3]
b. 18 Apr 1850 d. 22 Sep 1892
11
Philomela Callister
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.3.4]
b. 11 Jul 1851 d. 22 Feb 1879
11
Mary Maranda Callister
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.3.5]
b. 17 Aug 1853 d. 14 May 1930
11
Samuel Jay Callister
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.3.6]
b. 14 Jan 1856 d. 14 Jan 1856
11
Bathsheba Smith Callister
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.3.7]
b. 21 Sep 1860 d. 1 Nov 1860
10
John Lyman Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.8.4]
b. 17 Nov 1828 d. 21 Feb 1898
9
Susannah Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.9]
b. 18 May 1783 d. 22 Mar 1849
+
John Hall
9
Stephen Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.10]
b. 23 Apr 1785 d. 25 Jul 1802
+
Sally Hadley
9
Sarah Smith
[1.1.2.1.5.5.9.5.11]
b. 16 May 1789 d. 27 May 1824
Joseph Sanford
b. 1785 d. 11 Sep 1825
10
Martin Sanford
[1.1.2.1.5.5.9.5.11.1]
b. 24 Sep 1811 d. 24 Nov 1817
10
Martin Sanford
[1.1.2.1.5.5.9.5.11.2]
b. 4 Nov 1812 d. 3 Dec 1820
10
Joseph Sanford
[1.1.2.1.5.5.9.5.11.3]
b. 1813 d. 1816
10
Charlette Sanford
[1.1.2.1.5.5.9.5.11.4]
b. 4 Mar 1814 d. Abt 1858
10
William Wallace Sanford
[1.1.2.1.5.5.9.5.11.5]
b. 13 Jun 1816 d. 1844
10
John Lyman Sanford
[1.1.2.1.5.5.9.5.11.6]
b. 20 May 1818
6
Priscilla Gould
[1.1.2.1.5.6]
b. 2 Nov 1674 d. 16 Jun 1715
6
Captain Joseph Gould
[1.1.2.1.5.7]
b. 24 Aug 1677 d. 4 Apr 1753
6
Mary Gould
[1.1.2.1.5.8]
b. 16 Jun 1681 d. 11 May 1689
4
Anne Deacon
[1.1.2.2]
b. 22 Jun 1600 d. 22 Oct 1619
+
Richard Paine
b. 20 Feb 1596 bur. 18 May 1645
4
Thomas Deacon
[1.1.2.3]
b. 14 Feb 1602 d. Abt 1608
4
Elisha Deacon
[1.1.2.4]
b. 9 Jan 1603 d. 24 Oct 1658
+
Nancy
c. Abt 1608
4
Sarah Deacon
[1.1.2.5]
b. 25 Dec 1604
4
Martha Deacon
[1.1.2.6]
b. 22 Aug 1613
4
Daughter Deacon
[1.1.2.7]
b. 23 Oct 1619 d. Oct 1619
4
Son Deacon
[1.1.2.8]
b. 23 Oct 1619 d. 23 Oct 1619
3
Benjamin Field
[1.1.3]
b. 22 Aug 1581 d. 3 Sep 1581
3
Hannah Field
[1.1.4]
b. 22 Mar 1584
3
Seth Field
[1.1.5]
c. 25 Sep 1586 bur. 15 Jan 1588
3
Rebecka Field
[1.1.6]
c. 28 Sep 1589