Home Page
|
What's New
|
Photos
|
Histories
|
Headstones
|
Reports
|
Surnames
Search
First Name:
Last Name:
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Suomalainen
Svenska
William Brewster
1535 - 1608 (73 years)
Submit Photo / Document
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Submit Photo / Doc
Worksheet
Family
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
William Brewster
[1]
b. 1535 d. 10 Aug 1608
Mary Smythe
b. 1535 d. 17 Apr 1627
2
Henry Brewster
[1.1]
b. 1565 d. 20 Apr 1644
2
John Brewster
[1.2]
b. 1565 d. 23 Aug 1657
Katherine Patchinge
b. Abt 1594 d. 23 Feb 1657
3
Katherine Brewster
[1.2.1]
b. 20 Jun 1626 d. 23 Aug 1694
3
Richard Brewster
[1.2.2]
b. 4 Jan 1629
3
Elizabeth Brewster
[1.2.3]
b. 13 Feb 1632 d. 6 Apr 1638
3
Anna Brewster
[1.2.4]
b. 29 Jan 1634
3
Mary Brewster
[1.2.5]
b. 3 Apr 1636 d. 20 Aug 1639
3
Isaac Brewster
[1.2.6]
b. 2 May 1641
2
Elder William Brewster
[1.3]
b. Abt 1566 d. 10 Apr 1644
Mary
b. Abt 1569 d. 17 Apr 1627
3
Jonathan Brewster
[1.3.1]
b. 12 Aug 1593 d. 7 Aug 1659
Lucretia Oldham
b. Jan 1601 d. 4 Mar 1679
4
William Brewster
[1.3.1.1]
b. 9 Mar 1625 d. 15 Oct 1651
Mary Peame
b. 9 Mar 1625 d. 23 Mar 1698
5
Sarah Brewster
[1.3.1.1.1]
b. 25 Apr 1654 d. 2 Feb 1743
4
Mary Brewster
[1.3.1.2]
b. 16 Apr 1627 d. Aft 1698
John Turner
b. 22 Oct 1620 d. 28 Jun 1697
5
Jonathan Turner
[1.3.1.2.1]
b. 20 Sep 1646 d. 18 Apr 1724
Martha Bisbee
d. 24 Mar 1687
6
Isaac Turner
[1.3.1.2.1.1]
b. 27 Feb 1681 d. 1772
Mercy Hatch
6
Mercy Turner
[1.3.1.2.1.2]
b. 27 Oct 1690 d. May 1773
6
Ruth Turner
[1.3.1.2.1.3]
b. 6 Mar 1693
6
Ignatius Turner
[1.3.1.2.1.4]
b. 15 Mar 1697 d. 1778
6
Martha Turner
[1.3.1.2.1.5]
b. 24 Apr 1700
6
Jesse Turner
[1.3.1.2.1.6]
b. 2 Jul 1704
6
Mary Turner
[1.3.1.2.1.7]
b. 28 Jul 1706 d. 30 Aug 1753
5
Joseph Turner
[1.3.1.2.2]
b. 12 Jan 1647 d. 15 Jan 1647
5
Joseph Turner
[1.3.1.2.3]
b. 12 Jan 1648 d. 21 Jan 1694
Bathsheba Hobart
b. 28 Sep 1640 d. 14 Apr 1724
6
Margaret Turner
[1.3.1.2.3.1]
b. 20 Sep 1677 d. 17 Oct 1732
6
Bathsheba Turner
[1.3.1.2.3.2]
b. 30 Dec 1679 d. 6 Mar 1744
6
Joseph Turner
[1.3.1.2.3.3]
c. 11 Jun 1682 d. 7 May 1683
5
Ezekiel Turner
[1.3.1.2.4]
b. 7 Jan 1650 d. 19 Jan 1703
Susannah Keeney
b. 6 Sep 1662 d. 13 Dec 1748
6
Mary Turner
[1.3.1.2.4.1]
b. 30 May 1680
6
Sarah Turner
[1.3.1.2.4.2]
b. 28 Oct 1683 d. 15 Aug 1718
6
Susanna Keeney
[1.3.1.2.4.3]
b. 5 Jan 1685 d. 22 Feb 1753
6
Ruth Turner
[1.3.1.2.4.4]
b. 2 Mar 1688 bur. 1713
6
Lydia Turner
[1.3.1.2.4.5]
b. 5 Jun 1690
6
Hannah Turner
[1.3.1.2.4.6]
b. 8 Sep 1694 d. 1 Oct 1732
6
Elizabeth Turner
[1.3.1.2.4.7]
b. 5 Dec 1696 d. 1750
6
Grace Turner
[1.3.1.2.4.8]
b. 1698 d. 6 Jun 1784
6
Ezekiel Turner
[1.3.1.2.4.9]
b. Mar 1699 d. Mar 1770
6
Lucretia Turner
[1.3.1.2.4.10]
b. 20 Jan 1701 bur. 23 Sep 1756
6
Abigail Turner
[1.3.1.2.4.11]
b. 14 Mar 1703 d. 23 Sep 1756
Clement Miner
b. 14 Dec 1700 d. 9 Aug 1775
7
Lucy Miner
[1.3.1.2.4.11.1]
b. 8 Mar 1723 d. 24 May 1761
Nathan Howard
b. 29 Jan 1720 d. 2 Mar 1777
8
Daniel Howard
[1.3.1.2.4.11.1.1]
b. 15 Jan 1744 d. 14 Apr 1806
8
Nathan Howard, III
[1.3.1.2.4.11.1.2]
b. 10 Apr 1745 d. 25 Aug 1821
8
Grace Howard
[1.3.1.2.4.11.1.3]
b. 18 Oct 1746
8
Ezekiel Howard
[1.3.1.2.4.11.1.4]
b. 9 Nov 1748
8
Lucy Howard
[1.3.1.2.4.11.1.5]
b. 17 Jun 1750
8
David Howard
[1.3.1.2.4.11.1.6]
b. 17 Nov 1751
8
Thomas Howard
[1.3.1.2.4.11.1.7]
b. 22 Jun 1755 d. 22 Aug 1842
8
Joseph Howard
[1.3.1.2.4.11.1.8]
b. 19 Apr 1757 d. 22 Feb 1827
Elizabeth Davies
b. 3 Jul 1753 d. 10 Jun 1832
9
Theda Howard
[1.3.1.2.4.11.1.8.1]
b. Abt 1779
9
Athalia "Thalia" Howard
[1.3.1.2.4.11.1.8.2]
b. 21 Aug 1786 d. 4 Jun 1853
Joshua Grant, III
b. 5 Mar 1778 d. 7 Jan 1865
10
Joseph Grant
[1.3.1.2.4.11.1.8.2.1]
b. 27 Sep 1805 d. 25 Dec 1859
10
Lois Grant
[1.3.1.2.4.11.1.8.2.2]
b. 3 Aug 1807 d. 14 Aug 1867
10
Austin Gillette Grant
[1.3.1.2.4.11.1.8.2.3]
b. 30 Dec 1808 d. 30 Aug 1895
10
Nelson Grant
[1.3.1.2.4.11.1.8.2.4]
b. 16 Feb 1810 d. 27 Feb 1892
10
George Davis Grant
[1.3.1.2.4.11.1.8.2.5]
b. 10 Sep 1812 d. 20 Sep 1876
+
Rachel Ridgeway Ivins
b. 9 Mar 1821 d. 27 Jun 1909
10
Carolina Amanda Grant
[1.3.1.2.4.11.1.8.2.6]
b. 22 Jan 1814 d. 22 May 1845
William B Smith
b. 13 Mar 1811 d. 13 Nov 1893
11
Mary Jane Smith
[1.3.1.2.4.11.1.8.2.6.1]
b. 7 Jan 1834 d. 21 Dec 1878
11
Caroline L Smith
[1.3.1.2.4.11.1.8.2.6.2]
b. Aug 1839 d. 9 Jan 1878
10
Jedediah Morgan Grant
[1.3.1.2.4.11.1.8.2.7]
b. 21 Feb 1816 bur. 4 Dec 1856
Rachel Ridgeway Ivins
b. 9 Mar 1821 d. 27 Jun 1909
11
Heber Jeddy Grant
[1.3.1.2.4.11.1.8.2.7.1]
b. 22 Nov 1856 d. 14 May 1945
Lucy Stringham
b. 29 Apr 1858 d. 3 Jan 1893
12
Susan Rachel Grant
[1.3.1.2.4.11.1.8.2.7.1.1]
b. 30 Aug 1878 d. 10 Aug 1969
12
Lucy Grant
[1.3.1.2.4.11.1.8.2.7.1.2]
b. 22 Oct 1880 d. 27 May 1966
12
Florence Grant
[1.3.1.2.4.11.1.8.2.7.1.3]
b. 7 Feb 1883 d. 6 Mar 1977 [
=>
]
12
Edith Grant
[1.3.1.2.4.11.1.8.2.7.1.4]
b. 2 Apr 1885 d. 20 Aug 1947
12
Anna Grant
[1.3.1.2.4.11.1.8.2.7.1.5]
b. 28 Dec 1886 d. 6 Apr 1975 [
=>
]
12
Heber Stringham Grant
[1.3.1.2.4.11.1.8.2.7.1.6]
b. 9 Dec 1888 d. 27 Feb 1896
Hulda Augusta Winters
b. 7 Jul 1856 d. 1 Jun 1951
12
Mary Grant
[1.3.1.2.4.11.1.8.2.7.1.7]
b. 6 Feb 1889 d. 17 Dec 1955 [
=>
]
Emily Harris Wells
b. 22 Apr 1857 d. 25 May 1908
12
Martha Deseret Grant
[1.3.1.2.4.11.1.8.2.7.1.8]
b. 21 Apr 1886 d. 18 Sep 1970
12
Grace Grant
[1.3.1.2.4.11.1.8.2.7.1.9]
b. 21 Dec 1889 d. 24 Jan 1973
12
Daniel Wells Grant
[1.3.1.2.4.11.1.8.2.7.1.10]
b. 21 Nov 1891 d. 10 Mar 1895
12
Emily Grant
[1.3.1.2.4.11.1.8.2.7.1.11]
b. 5 Jun 1896 d. 31 Jul 1929
12
Frances Marion Grant
[1.3.1.2.4.11.1.8.2.7.1.12]
b. 23 Sep 1899 d. 17 Nov 1995
10
Joshua Frederick Grant
[1.3.1.2.4.11.1.8.2.8]
b. 24 Jul 1818 d. 21 Nov 1851
10
Theda C Grant
[1.3.1.2.4.11.1.8.2.9]
b. 13 Apr 1821 d. 13 May 1909
10
Thomas Jefferson Grant
[1.3.1.2.4.11.1.8.2.10]
b. 10 Jun 1823 d. 23 Feb 1899
10
Roxie Ann Grant
[1.3.1.2.4.11.1.8.2.11]
b. 16 Mar 1825 d. 30 Mar 1900
William B Smith
b. 13 Mar 1811 d. 13 Nov 1893
11
Thalia Grant Smith
[1.3.1.2.4.11.1.8.2.11.1]
b. 21 Sep 1848 d. 27 Nov 1924
11
Hyrum Wallace Smith
[1.3.1.2.4.11.1.8.2.11.2]
b. 17 Aug 1850 d. 27 Jan 1935
10
Howard Grant
[1.3.1.2.4.11.1.8.2.12]
b. 4 May 1827 d. 16 Feb 1859
9
Betsey Howard
[1.3.1.2.4.11.1.8.3]
b. Abt 1788
9
Mary Polly Howard
[1.3.1.2.4.11.1.8.4]
b. Abt 1790
9
Lucy Howard
[1.3.1.2.4.11.1.8.5]
b. Abt 1792
9
Rachel Howard
[1.3.1.2.4.11.1.8.6]
b. 1795 d. 21 Jan 1866
9
Sally Howard
[1.3.1.2.4.11.1.8.7]
b. 29 Nov 1797 d. 7 Jul 1883
8
Theda Redelia Howard
[1.3.1.2.4.11.1.9]
b. 25 Mar 1759 d. 25 May 1804
8
Benjamin Howard
[1.3.1.2.4.11.1.10]
b. 20 May 1761
7
Lydia Miner
[1.3.1.2.4.11.2]
b. 23 Oct 1724 d. 1787
7
Abigail Miner
[1.3.1.2.4.11.3]
b. 29 Nov 1726 d. 10 Aug 1755
7
Jonathan Miner
[1.3.1.2.4.11.4]
b. 10 Feb 1728 d. 30 Jan 1735
7
Edward Miner
[1.3.1.2.4.11.5]
b. 6 Jan 1730
7
Martha Miner
[1.3.1.2.4.11.6]
b. 7 Mar 1732 d. 11 Feb 1734
7
Clement Miner
[1.3.1.2.4.11.7]
b. 14 Apr 1735
7
Daniel Southold Miner
[1.3.1.2.4.11.8]
b. 20 May 1737 d. 27 Apr 1799
7
Mary Miner
[1.3.1.2.4.11.9]
b. 1 Jan 1744
7
William Miner
[1.3.1.2.4.11.10]
b. 1747
5
Lydia Turner
[1.3.1.2.5]
b. 24 Jan 1652 d. 20 Jan 1714
John James
b. 1655 d. 1676
6
Deacon John James
[1.3.1.2.5.1]
b. 10 Jan 1676 d. 28 Sep 1761
William Barrell
b. 19 Feb 1654 d. 7 Nov 1689
6
Mary Barrell
[1.3.1.2.5.2]
b. 22 May 1681
6
William Barrell, Jr
[1.3.1.2.5.3]
b. 22 Apr 1683
6
Lydia Barrell
[1.3.1.2.5.4]
b. 25 May 1684 d. 1768
6
Mary Barrell
[1.3.1.2.5.5]
b. 10 Sep 1686
6
James Barrell
[1.3.1.2.5.6]
b. 20 Sep 1687 d. 1 Jun 1710
5
John Turner
[1.3.1.2.6]
b. 30 Oct 1654 d. 13 Feb 1724
Abigail Padeshall
b. 1658 d. 20 Jan 1719
6
Joseph Turner
[1.3.1.2.6.1]
b. 1693 d. 1694
6
John Turner
[1.3.1.2.6.2]
b. 1695
6
Lydia Turner
[1.3.1.2.6.3]
b. 5 Jul 1699 d. 2 May 1771
6
Richard Turner
[1.3.1.2.6.4]
b. 5 Jun 1702 d. 29 Apr 1752
6
Abel Turner
[1.3.1.2.6.5]
b. 4 Oct 1706 d. 20 Sep 1798
5
Elisha Turner
[1.3.1.2.7]
b. 8 Mar 1657 d. 24 Apr 1700
Elizabeth Jacob
b. 11 Apr 1666 d. 17 Jan 1710
6
Elisha Turner
[1.3.1.2.7.1]
b. 11 Mar 1688 d. 7 May 1688
6
Mary Turner
[1.3.1.2.7.2]
b. 10 Jun 1690 d. 16 Apr 1774
6
Elizabeth Turner
[1.3.1.2.7.3]
b. 3 Apr 1692
6
Joel Turner
[1.3.1.2.7.4]
b. 5 Apr 1694 d. 1 Jan 1695
6
Joel Turner
[1.3.1.2.7.5]
b. 17 Aug 1697
6
Elisha Turner
[1.3.1.2.7.6]
b. 24 Jul 1700 d. 20 Jan 1735
6
Jacob Turner
[1.3.1.2.7.7]
c. 1695
5
Mary Turner
[1.3.1.2.8]
b. 19 Dec 1658 d. 10 Dec 1738
Isaac Prince
b. 9 Jul 1654 d. 7 Nov 1715
6
Alice Prince
[1.3.1.2.8.1]
b. 17 Dec 1680 d. 28 Sep 1755
6
Isaac Prince
[1.3.1.2.8.2]
b. 9 Oct 1682 d. 19 Sep 1719
6
Elisha Prince
[1.3.1.2.8.3]
b. 14 Apr 1684 d. 17 Aug 1707
6
Mary Prince
[1.3.1.2.8.4]
b. 25 Jul 1685 d. 7 Feb 1770
6
David Prince
[1.3.1.2.8.5]
b. 4 Oct 1687
6
Jacob Prince
[1.3.1.2.8.6]
b. 5 Oct 1690
6
James Prince
[1.3.1.2.8.7]
b. 16 Aug 1692
6
Joseph Prince
[1.3.1.2.8.8]
b. 5 Mar 1694 d. 20 Jan 1758
6
Caleb Prince
[1.3.1.2.8.9]
b. 24 Sep 1695
6
Ruth Prince
[1.3.1.2.8.10]
b. 10 Jun 1698 d. 1736
6
Honor Prince
[1.3.1.2.8.11]
b. 26 Oct 1701 d. 18 Jan 1777
5
Benjamin Turner
[1.3.1.2.9]
b. 5 Mar 1660 d. 12 Aug 1748
Elizabeth Hawkins
b. 1664 d. 1744
6
John Turner
[1.3.1.2.9.1]
b. 1 Jan 1693 d. 20 Mar 1778
6
Joseph Turner
[1.3.1.2.9.2]
b. 18 Apr 1694 d. 24 Dec 1735
6
Grace Turner
[1.3.1.2.9.3]
b. 17 Dec 1695 d. 16 Feb 1715
6
Elizabeth Turner
[1.3.1.2.9.4]
b. 1697 d. Apr 1780
6
William Turner
[1.3.1.2.9.5]
b. 5 Aug 1698 d. 12 Aug 1748
6
Hawkins Turner
[1.3.1.2.9.6]
b. 27 Aug 1704 d. Feb 1771
5
Ruth Turner
[1.3.1.2.10]
b. 17 May 1663 d. 1705
Thomas Prince
b. 8 Jul 1658 bur. 1704
6
Thomas Prince
[1.3.1.2.10.1]
b. 10 Jul 1686 d. 2 Nov 1754
6
James Prince
[1.3.1.2.10.2]
b. 1687
6
Ruth Prince
[1.3.1.2.10.3]
b. 6 Mar 1690 d. 12 Sep 1690
6
Benjamin Prince
[1.3.1.2.10.4]
b. 28 Feb 1693 d. 1 Dec 1737
6
Job Prince
[1.3.1.2.10.5]
b. 14 Apr 1695 d. Apr 1731
Israel Silvester, II
b. 23 Sep 1674 d. 13 Feb 1716
6
Ruth Silvester
[1.3.1.2.10.6]
b. 26 Jun 1702 d. 17 Nov 1779
6
Israel Silvester, III
[1.3.1.2.10.7]
b. 5 May 1705 d. 9 Nov 1785
6
Grace Silvester
[1.3.1.2.10.8]
b. Nov 1706 d. 2 Apr 1768
5
Isaac Turner
[1.3.1.2.11]
b. 30 Apr 1665 d. 4 Mar 1695
+
Sarah Stockbridge
b. 1663
5
Grace Turner
[1.3.1.2.12]
b. 2 Aug 1668 d. 1 Jun 1734
(Capt.) Richard Christophers
b. 13 Jul 1662 d. 9 Jun 1726
6
Joseph Christophers
[1.3.1.2.12.1]
b. 14 Jul 1692 d. 19 Dec 1716
6
Mary Christophers
[1.3.1.2.12.2]
b. 18 Sep 1694
6
Jonathan Christophers
[1.3.1.2.12.3]
b. 19 Sep 1696 d. 12 Oct 1696
6
Grace Christophers
[1.3.1.2.12.4]
b. 14 Oct 1698 d. 9 Nov 1745
6
(Son) Christophers
[1.3.1.2.12.5]
b. Sep 1699 d. Sep 1699
6
Lydia Christophers
[1.3.1.2.12.6]
b. 1700 d. 21 Jan 1740
6
Berie Or Benie Christophers
[1.3.1.2.12.7]
b. 12 Nov 1703 d. 4 Mar 1704
6
Ruth Christophers
[1.3.1.2.12.8]
b. 1704 d. 6 Jan 1775
6
Joanna Christophers
[1.3.1.2.12.9]
b. 19 Mar 1706 d. 1785
6
Lucy Christophers
[1.3.1.2.12.10]
b. 1709
6
Lucretia Christophers
[1.3.1.2.12.11]
b. 3 Mar 1709 d. 21 Mar 1747
5
Amos Turner
[1.3.1.2.13]
b. 4 Jun 1671 d. 13 Apr 1739
Mary Hilland
b. 15 May 1667 d. 5 Nov 1729
6
Amos Turner
[1.3.1.2.13.1]
b. 16 Nov 1695 d. 13 Apr 1739
6
Jane Turner
[1.3.1.2.13.2]
b. 4 May 1697
6
Anne Turner
[1.3.1.2.13.3]
b. 7 Apr 1699
6
Ezekial Turner
[1.3.1.2.13.4]
b. 1700 d. 10 Aug 1773
6
Mary Turner
[1.3.1.2.13.5]
b. 23 Apr 1704 d. 19 Aug 1775
6
Seth Turner
[1.3.1.2.13.6]
b. 28 Nov 1705 d. 10 Oct 1734
6
Lyda Turner
[1.3.1.2.13.7]
b. 1719
+
Hanah Clapp
b. 15 Jan 1673
4
Jonathan Brewster
[1.3.1.3]
b. 17 Jul 1629 d. 14 Sep 1710
4
Ruth Brewster
[1.3.1.4]
b. 3 Oct 1631 d. 1 May 1677
John Pickett
b. 1629 d. 16 Aug 1667
5
Mary Pickett
[1.3.1.4.1]
b. 16 Jan 1652 d. 15 Jan 1735
Captain Benjamin Shapley
b. Sep 1645 d. 3 Aug 1706
6
Ruth Shapley
[1.3.1.4.1.1]
b. 21 Dec 1672 d. 20 Oct 1739
6
Benjmain Shapely or Shapleigh
[1.3.1.4.1.2]
b. 20 Mar 1675 d. 1704
6
Mary Shapley
[1.3.1.4.1.3]
b. 26 Mar 1677 d. 24 Jul 1719
6
Joseph Shapley
[1.3.1.4.1.4]
b. 15 Aug 1681
6
Ann Shapely
[1.3.1.4.1.5]
b. 31 Aug 1685 d. 17 Jan 1751
6
Daniel Shapley
[1.3.1.4.1.6]
b. 14 Feb 1690 d. 17 Apr 1753
5
Ruth Pickett
[1.3.1.4.2]
b. 16 Dec 1653 d. 14 Sep 1690
Reverend Moses Noyes
b. 23 Sep 1648 d. 25 Oct 1734
6
Naomi Noyes
[1.3.1.4.2.1]
b. Abt 1676 d. 15 Mar 1728
William Comstock
b. 8 Jan 1669 d. 15 Mar 1728
7
John Comstock
[1.3.1.4.2.1.1]
b. 9 Aug 1696 d. 28 Mar 1767
Rebecca Bates
b. Abt 1704
8
Phebe Comstock
[1.3.1.4.2.1.1.1]
b. 16 Nov 1727
8
Curtis Comstock
[1.3.1.4.2.1.1.2]
b. 8 Oct 1729 d. 1772
8
Rebecca Comstock
[1.3.1.4.2.1.1.3]
b. 11 Feb 1732
8
Gideon Comstock
[1.3.1.4.2.1.1.4]
b. Abt 1736 d. 1746
7
William Comstock
[1.3.1.4.2.1.2]
b. 15 Jun 1698 d. 19 Jun 1765
Mary Bates
b. 1 Jul 1711 d. 29 Mar 1743
8
Abigail Comstock
[1.3.1.4.2.1.2.1]
c. 27 Apr 1726 d. 1776
8
William Comstock
[1.3.1.4.2.1.2.2]
b. 1733 d. 1773
8
Anne Comstock
[1.3.1.4.2.1.2.3]
b. Abt 1737
8
Naomi Comstock
[1.3.1.4.2.1.2.4]
b. 1739 d. 21 Dec 1831
8
Ruth Comstock
[1.3.1.4.2.1.2.5]
b. 18 Apr 1741 d. 18 Apr 1804
7
Abigail Comstock
[1.3.1.4.2.1.3]
b. 1700 d. 16 Oct 1773
Joseph Lord
b. 17 Oct 1697 d. 25 Jul 1736
8
Abigail Lord
[1.3.1.4.2.1.3.1]
b. 3 Feb 1726 d. 1771
8
Joseph Lord
[1.3.1.4.2.1.3.2]
b. 3 Feb 1726 d. 13 Mar 1788
8
Benjamin Lord
[1.3.1.4.2.1.3.3]
b. 3 Jan 1728 d. 6 Feb 1805
8
Elijah Lord
[1.3.1.4.2.1.3.4]
b. 1 Jan 1730
8
Elizabeth Lord
[1.3.1.4.2.1.3.5]
b. 19 Aug 1732 d. 20 Dec 1753
8
Sylvanus Lord
[1.3.1.4.2.1.3.6]
b. 21 Aug 1734 d. 29 Nov 1762
8
Captain Daniel Lord
[1.3.1.4.2.1.3.7]
b. 1736 d. 21 Sep 1796
7
Ruth Comstock
[1.3.1.4.2.1.4]
b. Abt 1702
+
Jonathan Reed
b. 15 Apr 1686
7
Elizabeth Comstock
[1.3.1.4.2.1.5]
b. Abt 1704
+
McCrary
b. 1702
7
Phoebe Comstock
[1.3.1.4.2.1.6]
b. 1706 d. 1 Dec 1790
Lemuel Griffin
b. 23 Mar 1706 d. 15 Aug 1788
8
George Griffin
[1.3.1.4.2.1.6.1]
b. 10 Jul 1734 d. 6 Aug 1814
8
Lemuel Griffin
[1.3.1.4.2.1.6.2]
b. Abt 1736 d. 9 Jul 1810
8
Josiah Griffen
[1.3.1.4.2.1.6.3]
b. 21 Jul 1743
7
Naomi Comstock
[1.3.1.4.2.1.7]
b. 1708 d. 29 May 1743
Consider Tiffany
b. 28 Apr 1703 d. 29 May 1763
8
Consider Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.1]
b. 15 Mar 1732 d. 19 Jun 1796
Sarah Wilder
b. 13 Aug 1738 d. 7 Nov 1818
9
Jemima Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.1.1]
b. 12 Oct 1756 d. 24 Jul 1784
9
Ephriam Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.1.2]
b. 8 Nov 1758 d. 7 Apr 1818
9
Dorothy Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.1.3]
b. 19 Jun 1762 d. 7 Nov 1818
9
Levi Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.1.4]
b. 23 Apr 1766 d. 20 Nov 1851
9
Consider Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.1.5]
b. 12 Mar 1769 d. 4 Sep 1859
9
Betty Wilder Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.1.6]
b. 25 Feb 1772 d. 16 Feb 1837
9
Mary Willey Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.1.7]
b. 1 Apr 1775
9
Lewis Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.1.8]
b. Abt 1777 d. 13 Nov 1777
9
Dolly Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.1.9]
b. Abt 1779
8
Luther Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.2]
b. 15 Apr 1734
8
Naomi Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.3]
b. 28 Dec 1737 d. 25 Jul 1821
Ezekial Huntley
b. 9 Mar 1728 d. 25 Jul 1783
9
Rufus Huntley
[1.3.1.4.2.1.7.3.1]
b. 18 Sep 1764 d. 4 Apr 1860
9
Lois Huntley
[1.3.1.4.2.1.7.3.2]
b. 18 Sep 1764 d. 2 Feb 1848
9
Elias Huntley
[1.3.1.4.2.1.7.3.3]
b. 28 Jul 1765 d. 10 Jan 1783
9
Asher Hulbert
[1.3.1.4.2.1.7.3.4]
b. 1 Mar 1767 d. 1 Mar 1849
9
Naomi Huntley
[1.3.1.4.2.1.7.3.5]
b. Abt 1768 d. 2 Dec 1840
9
Ezra Huntley
[1.3.1.4.2.1.7.3.6]
b. 2 Jun 1771 d. 13 Apr 1817
9
Ezekiel Huntley, Jr
[1.3.1.4.2.1.7.3.7]
b. 21 May 1780 d. 5 Mar 1853
8
Samuel Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4]
b. 13 Jul 1740 d. Mar 1822
Abigail Curtis
b. 17 Mar 1742 d. May 1820
9
Samuel Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.1]
b. 21 Oct 1761 d. 21 Apr 1851
Mary Sackett
b. Abt 1761 d. 1862
10
Samuel Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.1.1]
b. 1788 d. Abt 1845
10
Mary Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.1.2]
b. 1797
10
Julia Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.1.3]
b. 1799 d. 13 Jan 1891
10
Thomas Jefferson Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.1.4]
b. 1801
10
Hannah Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.1.5]
b. 5 Apr 1804 d. 10 Sep 1860
10
Calinda Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.1.6]
b. 2 Dec 1807 d. 5 Mar 1866
10
Ezekiel Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.1.7]
b. 1810
10
Jefferson Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.1.8]
b. Abt 1810
10
Harry Edward Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.1.9]
b. 25 Jun 1813 d. 14 Dec 1871
10
Harriet Emeline Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.1.10]
b. Abt 1815
10
Lorenzo Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.1.11]
b. Abt 1818
9
Nathanial Curtis Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.2]
b. 18 Feb 1762 d. 13 Feb 1857
Dency Crane
b. Abt 1765
10
Nathaniel Curtis Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.2.1]
b. Mar 1790
10
Harriet Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.2.2]
b. Mar 1792 d. 1858
10
Dancy Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.2.3]
b. 25 Sep 1795 d. 24 Mar 1846
10
Anron Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.2.4]
b. 2 Jun 1797 d. 27 Feb 1847
10
Betsey Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.2.5]
b. Abt 1799
10
David Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.2.6]
b. 1800
10
Mary Polly Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.2.7]
b. 17 Dec 1801 d. 20 May 1835
10
Elizabeth Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.2.8]
b. 1805
10
Caroline Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.2.9]
b. Abt 1807 d. 1843
9
Jemima Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.3]
b. 1763 d. 6 Mar 1848
Reuben Ward
b. 13 Nov 1748 d. 5 Jul 1825
10
Affa Ward
[1.3.1.4.2.1.7.4.3.1]
b. 27 May 1783 d. 28 Feb 1877
William Stilson
b. 23 Sep 1783 d. 4 May 1862
11
Caroline Stilson
[1.3.1.4.2.1.7.4.3.1.1]
b. 20 Jan 1808 d. 12 Jan 1883
11
Albert Stilson
[1.3.1.4.2.1.7.4.3.1.2]
b. 16 Jan 1810 d. 30 Sep 1895
11
Celinda Stilson
[1.3.1.4.2.1.7.4.3.1.3]
b. 4 Feb 1811 d. 26 Jun 1845
11
Emeline Stilson
[1.3.1.4.2.1.7.4.3.1.4]
b. 27 Sep 1813 d. 6 Jan 1887
11
William M Stilson
[1.3.1.4.2.1.7.4.3.1.5]
b. 2 Apr 1816
11
Saphronia Stilson
[1.3.1.4.2.1.7.4.3.1.6]
b. 3 Nov 1817 d. 6 Jan 1887
11
Minor Stilson
[1.3.1.4.2.1.7.4.3.1.7]
b. 9 Jan 1821
11
Affa C Stilson
[1.3.1.4.2.1.7.4.3.1.8]
b. 31 Mar 1823 d. Abt 1879
11
Rueben R Stilson
[1.3.1.4.2.1.7.4.3.1.9]
b. 29 Dec 1824
11
Allen Stilson
[1.3.1.4.2.1.7.4.3.1.10]
b. 12 Apr 1827 d. 25 Jan 1878
10
Reuben Ward
[1.3.1.4.2.1.7.4.3.2]
b. Abt 1784 d. 5 Mar 1876
10
Jemima Ward
[1.3.1.4.2.1.7.4.3.3]
b. Abt 1786
10
Laura Ward
[1.3.1.4.2.1.7.4.3.4]
b. Abt 1790
10
Eda Ward
[1.3.1.4.2.1.7.4.3.5]
b. Abt 1788
10
Samuel Ward
[1.3.1.4.2.1.7.4.3.6]
b. Abt 1792 d. 23 Feb 1873
10
Dorcas Ward
[1.3.1.4.2.1.7.4.3.7]
b. Abt 1794
10
Cynthia Ward
[1.3.1.4.2.1.7.4.3.8]
b. Abt 1796
+
Henry Rolluff
b. Abt 1782
10
William B Ward
[1.3.1.4.2.1.7.4.3.9]
b. 1801
10
Daniel Ward
[1.3.1.4.2.1.7.4.3.10]
b. 1807
9
William Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.4]
b. Abt 1765
9
Emellason Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.5]
b. Abt 1765 d. 18 Mar 1847
Sarah Aldrich
b. 4 Apr 1773
10
Rhoda Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.5.1]
b. 1 Nov 1793
10
George Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.5.2]
b. 5 May 1794
10
Lemuel Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.5.3]
b. 30 Jun 1796
10
David Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.5.4]
b. 18 Aug 1798
10
Sarah Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.5.5]
b. 27 Mar 1803 d. 14 Nov 1838
10
Silas Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.5.6]
b. 13 Apr 1809
9
Daniel Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.6]
b. 18 Sep 1768 d. 25 Sep 1793
+
Phebe Rand
b. Abt 1770
9
Abigail Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.7]
b. Abt 1770
+
Zenos Aldrich
b. 1766 d. 8 Nov 1856
9
George Obediah Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.8]
b. 7 May 1772 d. 13 Feb 1857
Mary Mason
b. Abt 1766 d. 16 Mar 1840
10
Abigail Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.1]
b. Abt 1797 d. Dec 1859
10
Zilpha Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.2]
b. Abt 1799 d. 1830
10
Zenas Schovil Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.3]
b. 25 Jun 1801 d. 1822
10
Luther Little Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.4]
b. 28 Mar 1803 d. 17 Feb 1881
10
Frederick Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.5]
b. 1804 d. 1804
10
Lorenzo Mason Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.6]
b. Abt 1804 d. Abt 1809
10
Jane Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.7]
b. 14 Apr 1805 d. 26 Nov 1867
10
George Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.8]
b. 4 May 1808 d. 21 Jun 1885
Almira Whipple
b. 13 Jun 1810 d. 4 Feb 1889
11
Cynthia Jane Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.8.1]
b. 2 Feb 1830 d. 6 Oct 1845
11
Zenos Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.8.2]
b. 21 Jul 1831 d. Dec 1843
11
Ira Patchen Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.8.3]
b. 14 Feb 1835 d. 21 Mar 1905
Mary Ann Davis
b. 4 Oct 1843 d. 21 Jul 1885
12
Ira Davies Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.8.3.1]
b. 24 Jul 1863 d. 27 Oct 1902
12
Zenos William Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.8.3.2]
b. 21 Aug 1865 d. 14 Feb 1938
12
Sylvia Ann Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.8.3.3]
b. 14 Nov 1867 d. 23 Dec 1936
12
Cynthia Jane Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.8.3.4]
b. 27 Feb 1870 d. Bef 1877
12
Mary Elizabeth Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.8.3.5]
b. 17 May 1871 d. 5 Nov 1887
12
Almira Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.8.3.6]
b. 29 Dec 1873 d. 21 Sep 1887
12
Franklin Brayn Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.8.3.7]
b. 29 Feb 1876 d. 4 Oct 1877
12
Eliza Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.8.3.8]
b. 30 Jan 1878 d. 2 Jun 1957
12
George Hyrum Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.8.3.9]
b. 17 Apr 1880 d. 18 Mar 1939
12
Albert Henry Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.8.3.10]
b. 5 Nov 1882 d. 2 Dec 1956
12
Ray Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.8.3.11]
b. 21 Jul 1884 d. 16 Oct 1885
+
Sarah Ann Jolley
b. 18 Dec 1837 d. 9 Jan 1919
11
Loyal Peck Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.8.4]
b. 27 Jul 1837 d. 15 Feb 1903
+
Martha Holden
b. 28 Jan 1825 d. 3 May 1886
11
Mary Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.8.5]
b. 18 Dec 1844 d. 14 Dec 1845
11
Almira Rebecca Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.8.6]
b. 18 Aug 1847 d. 23 Nov 1914
Giles Bliss Holden
b. 8 May 1842 d. 20 May 1897
12
Almira Rebecca Holden
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.8.6.1]
b. 8 Aug 1865 d. 25 Aug 1865
12
Ruia Angeline Holden
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.8.6.2]
b. 21 Oct 1866 d. 4 Mar 1948
12
Giles Robert Holden
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.8.6.3]
b. 8 Dec 1868 d. Mar 1889
12
Cynthia Holden
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.8.6.4]
b. 10 Mar 1870 d. 10 Mar 1870
12
George Tiffany Holden
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.8.6.5]
b. 9 May 1872 d. 13 Apr 1934
12
Nellie May Holden
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.8.6.6]
b. 30 Dec 1875 d. 6 Nov 1935
12
Burrell Henry Holden
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.8.6.7]
b. 29 Jun 1877 d. 11 Mar 1881
12
Leroy Edwin Holden
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.8.6.8]
b. 21 Sep 1879 d. 12 Feb 1881
12
Ivy LeNore Holden
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.8.6.9]
b. 24 May 1882 d. 18 Aug 1958
12
Merle Dee Holden
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.8.6.10]
b. 10 Jul 1885 d. 12 Sep 1938
12
Verna Holden
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.8.6.11]
b. 18 Dec 1887 d. 18 Dec 1887
12
Vera Holden
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.8.6.12]
b. 18 Dec 1887 d. 12 Feb 1967 [
=>
]
11
George Mason Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.8.7]
b. 31 Jan 1850 d. 14 Mar 1909
Sarah Jane York
b. 18 Feb 1857 d. 27 Dec 1940
12
Mary Ellen Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.8.7.1]
b. 22 Aug 1874 d. 18 Jun 1958
12
Sarah Jane Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.8.7.2]
b. 16 Apr 1876 d. 23 Apr 1883
12
George Mason Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.8.7.3]
b. 17 Nov 1877 d. 21 Apr 1883
12
Asa York Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.8.7.4]
b. 24 Feb 1881 d. 3 Feb 1947
12
Lea Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.8.7.5]
b. 7 May 1883 d. 7 Jan 1961
12
Ira George Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.8.7.6]
b. 7 May 1883 d. 7 Jan 1961
12
Nelson Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.8.7.7]
b. 4 Aug 1885 d. 27 Mar 1943
12
Almira Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.8.7.8]
b. 16 Sep 1888 d. 26 Jul 1966
12
Ruia Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.8.7.9]
b. 27 Nov 1890 d. 15 May 1965
12
Lenore Henrietta Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.8.7.10]
b. 9 Aug 1893 d. 11 Sep 1967
11
Nelson Whipple Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.8.8]
b. 6 Aug 1852 d. 20 Jan 1927
Nancy Medora Beesley
b. 8 Sep 1862 d. 15 May 1924
12
Nelson Whipple Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.8.8.1]
b. 11 Sep 1880 d. 20 Nov 1904
12
Florence Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.8.8.2]
b. 27 Apr 1882 d. 22 May 1964
12
Alathea Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.8.8.3]
b. 28 Aug 1884 d. 3 Jan 1897
12
Ida May Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.8.8.4]
b. 15 Nov 1888 d. 9 May 1968
12
George Milton Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.8.8.5]
b. 8 May 1892 d. 25 May 1963
12
Martha Elva Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.8.8.6]
b. 1 Aug 1898 d. 25 Nov 1989
12
Viola Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.8.8.7]
b. 5 Jul 1903 d. 19 Jun 1969
10
Lorenzo Roderick Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.9]
b. 4 Jul 1810 d. Abt 1810
10
Richard Mason Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.10]
b. 4 Jul 1810 d. 1897
10
Daniel Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.11]
b. 12 Sep 1812 d. 25 Jan 1894
10
Mary Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.12]
b. 28 Mar 1814 d. 1899
10
Phebe Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.13]
b. 24 Oct 1817 d. 20 Feb 1850
10
Larena Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.14]
b. 1818 d. 1844
10
Ann Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.8.15]
b. 4 Jun 1822 d. 12 Sep 1893
9
Mary Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.9]
b. 17 Jun 1777 d. 12 Sep 1845
Daniel Whipple
b. 27 Aug 1779 d. 27 Sep 1839
10
Cynthia Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.1]
b. 15 Jan 1805 d. 1889
Ezra Gray
b. 1793 d. 1870
11
Hiram T Gray
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.1.1]
b. 25 Aug 1832 d. 30 Jun 1875
+
Caroline R Lane
b. 1839 d. 1902
11
Daniel William Gray
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.1.2]
b. 19 May 1834 d. 9 Dec 1890
Eliza Jane Ostrander
b. Abt 1840 d. 29 Oct 1861
12
William Delvin Grey
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.1.2.1]
b. 27 Feb 1859 d. 11 Aug 1949
12
Frank Gray
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.1.2.2]
b. Abt 1861
Sarah Ann Smith
b. 19 Dec 1851 d. 15 Jan 1941
12
Jennie Gray
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.1.2.3]
b. 3 May 1870 d. 5 Oct 1941
12
Nellie F Gray
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.1.2.4]
b. 2 Jul 1871 d. Aug 1883
12
Frank N Gray
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.1.2.5]
b. 3 Nov 1873
12
Mary Ellen Gray
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.1.2.6]
b. 27 Aug 1877 d. 23 Feb 1953
12
Carrie M Gray
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.1.2.7]
b. 8 Dec 1881 d. 12 Sep 1949
11
Daughter Gray
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.1.3]
b. 1834
11
Emily Jane Gray
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.1.4]
b. 14 Nov 1837 d. 13 Feb 1908
11
Betsey T Gray
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.1.5]
b. 1840
11
Mary M Gray
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.1.6]
b. 1844
11
George W Gray
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.1.7]
b. 1846 d. 4 Aug 1918
Sidney
b. Jan 1846
12
Ramond G Gray
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.1.7.1]
b. Apr 1869
12
Minnie M Gray
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.1.7.2]
b. May 1872 [
=>
]
12
Floyd Gray
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.1.7.3]
b. Sep 1874
12
Daisey M Gray
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.1.7.4]
b. Jun 1881
10
Samuel Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.2]
b. 21 Dec 1808 d. 9 Jan 1887
Phoebe Kingsbury
b. 14 Dec 1812 d. 24 Apr 1851
11
Sabrina Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.2.1]
b. 30 Mar 1832 d. 1920
+
Scudder Todd
b. 1831 d. 1901
11
George T Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.2.2]
b. 4 Dec 1833 d. 28 Aug 1868
11
Polly Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.2.3]
b. 4 Jun 1835 d. 24 Mar 1855
11
Daniel Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.2.4]
b. 21 Jun 1837
11
Margaret Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.2.5]
b. 18 Jun 1839 d. 8 Oct 1840
11
Mason Kingsbury Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.2.6]
b. 17 Feb 1842 d. 27 Mar 1919
Olive Amanda Kingsbury
b. 10 Dec 1844 d. 1924
12
Nelson E Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.2.6.1]
b. 1867 d. 1943
12
Ina Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.2.6.2]
b. Sep 1869
12
George W Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.2.6.3]
b. Jan 1872
12
Pearl O Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.2.6.4]
b. Jun 1884
11
Samuel Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.2.7]
b. 4 Mar 1844 d. May 1924
11
Hassett Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.2.8]
b. 20 Feb 1846 d. 3 Jan 1852
11
Almira Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.2.9]
b. 21 Apr 1848 d. 22 Sep 1911
+
Franklin F King
b. 1845 d. 1898
11
Cynthia Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.2.10]
b. 10 Nov 1850 d. 17 Apr 1851
10
Almira Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.3]
b. 13 Jun 1810 d. 4 Feb 1889
George Tiffany
b. 4 May 1808 d. 21 Jun 1885
11
Cynthia Jane Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.3.1]
b. 2 Feb 1830 d. 6 Oct 1845
11
Zenos Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.3.2]
b. 21 Jul 1831 d. Dec 1843
11
Ira Patchen Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.3.3]
b. 14 Feb 1835 d. 21 Mar 1905
Mary Ann Davis
b. 4 Oct 1843 d. 21 Jul 1885
12
Ira Davies Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.3.3.1]
b. 24 Jul 1863 d. 27 Oct 1902
12
Zenos William Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.3.3.2]
b. 21 Aug 1865 d. 14 Feb 1938
12
Sylvia Ann Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.3.3.3]
b. 14 Nov 1867 d. 23 Dec 1936
12
Cynthia Jane Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.3.3.4]
b. 27 Feb 1870 d. Bef 1877
12
Mary Elizabeth Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.3.3.5]
b. 17 May 1871 d. 5 Nov 1887
12
Almira Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.3.3.6]
b. 29 Dec 1873 d. 21 Sep 1887
12
Franklin Brayn Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.3.3.7]
b. 29 Feb 1876 d. 4 Oct 1877
12
Eliza Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.3.3.8]
b. 30 Jan 1878 d. 2 Jun 1957
12
George Hyrum Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.3.3.9]
b. 17 Apr 1880 d. 18 Mar 1939
12
Albert Henry Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.3.3.10]
b. 5 Nov 1882 d. 2 Dec 1956
12
Ray Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.3.3.11]
b. 21 Jul 1884 d. 16 Oct 1885
+
Sarah Ann Jolley
b. 18 Dec 1837 d. 9 Jan 1919
11
Loyal Peck Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.3.4]
b. 27 Jul 1837 d. 15 Feb 1903
+
Martha Holden
b. 28 Jan 1825 d. 3 May 1886
11
Mary Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.3.5]
b. 18 Dec 1844 d. 14 Dec 1845
11
Almira Rebecca Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.3.6]
b. 18 Aug 1847 d. 23 Nov 1914
Giles Bliss Holden
b. 8 May 1842 d. 20 May 1897
12
Almira Rebecca Holden
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.3.6.1]
b. 8 Aug 1865 d. 25 Aug 1865
12
Ruia Angeline Holden
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.3.6.2]
b. 21 Oct 1866 d. 4 Mar 1948
12
Giles Robert Holden
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.3.6.3]
b. 8 Dec 1868 d. Mar 1889
12
Cynthia Holden
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.3.6.4]
b. 10 Mar 1870 d. 10 Mar 1870
12
George Tiffany Holden
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.3.6.5]
b. 9 May 1872 d. 13 Apr 1934
12
Nellie May Holden
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.3.6.6]
b. 30 Dec 1875 d. 6 Nov 1935
12
Burrell Henry Holden
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.3.6.7]
b. 29 Jun 1877 d. 11 Mar 1881
12
Leroy Edwin Holden
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.3.6.8]
b. 21 Sep 1879 d. 12 Feb 1881
12
Ivy LeNore Holden
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.3.6.9]
b. 24 May 1882 d. 18 Aug 1958
12
Merle Dee Holden
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.3.6.10]
b. 10 Jul 1885 d. 12 Sep 1938
12
Verna Holden
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.3.6.11]
b. 18 Dec 1887 d. 18 Dec 1887
12
Vera Holden
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.3.6.12]
b. 18 Dec 1887 d. 12 Feb 1967 [
=>
]
11
George Mason Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.3.7]
b. 31 Jan 1850 d. 14 Mar 1909
Sarah Jane York
b. 18 Feb 1857 d. 27 Dec 1940
12
Mary Ellen Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.3.7.1]
b. 22 Aug 1874 d. 18 Jun 1958
12
Sarah Jane Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.3.7.2]
b. 16 Apr 1876 d. 23 Apr 1883
12
George Mason Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.3.7.3]
b. 17 Nov 1877 d. 21 Apr 1883
12
Asa York Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.3.7.4]
b. 24 Feb 1881 d. 3 Feb 1947
12
Lea Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.3.7.5]
b. 7 May 1883 d. 7 Jan 1961
12
Ira George Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.3.7.6]
b. 7 May 1883 d. 7 Jan 1961
12
Nelson Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.3.7.7]
b. 4 Aug 1885 d. 27 Mar 1943
12
Almira Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.3.7.8]
b. 16 Sep 1888 d. 26 Jul 1966
12
Ruia Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.3.7.9]
b. 27 Nov 1890 d. 15 May 1965
12
Lenore Henrietta Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.3.7.10]
b. 9 Aug 1893 d. 11 Sep 1967
11
Nelson Whipple Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.3.8]
b. 6 Aug 1852 d. 20 Jan 1927
Nancy Medora Beesley
b. 8 Sep 1862 d. 15 May 1924
12
Nelson Whipple Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.3.8.1]
b. 11 Sep 1880 d. 20 Nov 1904
12
Florence Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.3.8.2]
b. 27 Apr 1882 d. 22 May 1964
12
Alathea Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.3.8.3]
b. 28 Aug 1884 d. 3 Jan 1897
12
Ida May Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.3.8.4]
b. 15 Nov 1888 d. 9 May 1968
12
George Milton Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.3.8.5]
b. 8 May 1892 d. 25 May 1963
12
Martha Elva Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.3.8.6]
b. 1 Aug 1898 d. 25 Nov 1989
12
Viola Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.3.8.7]
b. 5 Jul 1903 d. 19 Jun 1969
10
Phoebe Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.4]
b. 13 Aug 1813 d. 18 Nov 1846
Benjamin Bengraw Shaw
b. 1808
11
Clymenia Azuba Shaw
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.4.1]
b. 2 Feb 1834 d. 10 Aug 1920
David Evans
b. 27 Oct 1804 d. 23 Jun 1883
12
Phebe Jane Evans
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.4.1.1]
b. 1 Dec 1855 d. 18 Dec 1855
12
James Evans
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.4.1.2]
b. 16 Aug 1857 d. 15 Apr 1940 [
=>
]
12
Edwin Thomas Evans
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.4.1.3]
b. 2 Feb 1860 d. 4 Mar 1946 [
=>
]
Benjamin Gibson
b. 9 May 1805 d. 26 Nov 1897
11
Hannah Gibson
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.4.2]
b. 24 Apr 1836 d. 31 Oct 1846
11
Isabella Amy Gibson
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.4.3]
b. 20 Mar 1838 d. 11 Feb 1898
William Coleman
b. 9 Dec 1836 d. 12 Feb 1910
12
William Coleman, Jr
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.4.3.1]
b. 3 Oct 1858 d. 19 Aug 1936 [
=>
]
12
Phebe Jane Coleman
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.4.3.2]
b. 20 May 1860 d. 11 Jun 1936 [
=>
]
12
Benjamin Leo Coleman
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.4.3.3]
b. 2 Sep 1862 d. 23 Jan 1937 [
=>
]
12
Amy Jane Coleman
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.4.3.4]
b. 13 May 1865 d. 19 Oct 1865
12
Mary Elizabeth Coleman
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.4.3.5]
b. 12 Apr 1866 d. 12 Dec 1869
12
John Coleman
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.4.3.6]
b. 6 Nov 1866 d. 24 Jul 1937 [
=>
]
12
Franklin Coleman
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.4.3.7]
b. 18 Mar 1868 d. 1 Jul 1917 [
=>
]
12
Hyrum Coleman
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.4.3.8]
b. 19 Aug 1868 d. 8 Oct 1947 [
=>
]
12
Prime Henry Coleman
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.4.3.9]
b. 24 Apr 1871 d. 30 Mar 1948
12
Sarah Francetta Coleman
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.4.3.10]
b. 20 Jun 1875 d. 9 May 1931 [
=>
]
12
Esther Coleman
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.4.3.11]
b. 8 Dec 1880 d. 1 Mar 1908 [
=>
]
11
Mary Jane Gibson
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.4.4]
b. 5 Feb 1840 d. 12 Jun 1912
Orson Kelsey
b. 1 Oct 1840 d. 7 May 1922
12
Mary Ellen Kelsey
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.4.4.1]
b. 22 Jan 1860 d. 28 Oct 1889 [
=>
]
12
Orson Kelsey, Jr
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.4.4.2]
b. 27 Aug 1861 d. 23 Mar 1904 [
=>
]
12
Benjamin Franklin Kelsey
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.4.4.3]
b. 6 Jun 1865 d. 28 Sep 1937 [
=>
]
12
Orin Kelsey
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.4.4.4]
b. 27 Sep 1866 d. 28 Sep 1866
12
George Albert Kelsey
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.4.4.5]
b. 6 Nov 1868 d. 10 Sep 1946
12
Theodore Kelsey
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.4.4.6]
b. 20 May 1871 d. 2 May 1963 [
=>
]
12
Abigail Kelsey
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.4.4.7]
b. 17 Feb 1873 d. 10 Dec 1956 [
=>
]
12
Easton Lemoine Kelsey
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.4.4.8]
b. 18 Oct 1875 d. 23 Jul 1963 [
=>
]
12
Amos C Kelsey
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.4.4.9]
b. 26 Jul 1876 d. 5 Sep 1956 [
=>
]
12
Rupert Lee Kelsey
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.4.4.10]
b. 8 Dec 1878 d. 12 Aug 1961 [
=>
]
12
Elmira Kelsey
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.4.4.11]
b. 10 Nov 1880 d. 19 Feb 1958 [
=>
]
12
Phoebe Jane Kelsey
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.4.4.12]
b. 23 Aug 1882 d. 16 Jul 1964 [
=>
]
11
Susan Jane Gibson
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.4.5]
b. 11 Oct 1842 d. 25 May 1929
John Franklin Sanders
b. 5 Mar 1830 d. 18 Mar 1896
12
Phebe Jane Sanders
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.4.5.1]
b. 23 Jan 1866 d. 9 May 1950 [
=>
]
12
Amanda Ann Sanders
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.4.5.2]
b. 14 Nov 1867 d. Aug 1868
12
Amy Elmira Sanders
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.4.5.3]
b. 8 Aug 1869 d. 25 Sep 1925
12
William Franklin Sanders
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.4.5.4]
b. 6 Jan 1872 d. 15 Nov 1906
12
Ellen Clymena Sanders
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.4.5.5]
b. 14 Jan 1874 d. 8 Oct 1953 [
=>
]
12
Joseph Myron Sanders
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.4.5.6]
b. 12 Mar 1876 d. 8 Jun 1944 [
=>
]
11
Jemima Gibson
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.4.6]
b. 1847
10
Carum Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.5]
b. 12 Aug 1815 d. 1843
10
Gerua Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.6]
b. 12 Aug 1815 d. 18 Sep 1848
10
Nelson Wheeler Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7]
b. 11 Jul 1818 d. 5 Jul 1887
Susan Jane Bailey
b. 9 Mar 1828 d. 5 Jun 1856
11
Son Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.1]
b. 15 Oct 1844 d. 15 Oct 1844
11
Miranda Jane Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.2]
b. 14 Mar 1847 d. 29 Dec 1907
+
John Williams
b. 8 Oct 1840 d. 21 May 1899
David R Barton
b. 1835
12
David Albert Barton
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.2.1]
b. 22 Jan 1865 d. 3 Sep 1930
12
Elizabeth M Barton
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.2.2]
b. Apr 1868 d. 15 Oct 1917 [
=>
]
12
Mary Ellen Barton
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.2.3]
b. 26 Jul 1870 d. 2 Feb 1926 [
=>
]
Henry Codd
b. 21 Aug 1836 d. 20 Jan 1911
12
Eliza Isabella Code
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.2.4]
b. 12 Nov 1873 d. 13 Mar 1911
12
Charles Levi Code
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.2.5]
b. 3 Apr 1876 d. 4 May 1954
12
Ruth Lorena Code
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.2.6]
b. 21 Apr 1880 d. 16 Nov 1939
12
Theda Maria Code
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.2.7]
b. 2 Jul 1883 d. 11 Jun 1932
11
Mary Janet Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.3]
b. 14 Feb 1849 d. Nov 1922
Charles Maynard
b. Abt 1849
12
Charles Maynard
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.3.1]
b. 1880
+
Richard Marlin Wadams
b. 4 Aug 1852 d. 11 Apr 1914
11
George Nelson Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.4]
b. 20 Mar 1851 d. 8 Jun 1912
Annie Baird
b. 5 Nov 1860 d. 1926
12
William Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.4.1]
b. Abt 1883 d. Abt 1888
12
Frank Henry Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.4.2]
b. 6 Dec 1885 d. 5 Sep 1946 [
=>
]
12
Edson George Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.4.3]
b. 25 Apr 1891 d. 4 Mar 1939
12
Ida Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.4.4]
b. Abt 1899 d. 4 Jun 1899
12
Mary Jannett Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.4.5]
b. 16 Apr 1900 d. 3 Aug 1900
12
Edith May Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.4.6]
b. 21 Nov 1903 d. 9 Oct 1945 [
=>
]
11
Edson Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.5]
b. 10 Oct 1853 d. 26 Feb 1909
Mary Ann Beck
b. 13 Jun 1865 d. 16 Jan 1937
12
Mary Magdaline Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.5.1]
b. 8 Oct 1881 d. 24 Feb 1964 [
=>
]
12
Susan Jane Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.5.2]
b. 17 Oct 1883 d. 25 Apr 1965 [
=>
]
12
William Edson Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.5.3]
b. 19 Oct 1885 d. 10 Mar 1976 [
=>
]
12
Luella Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.5.4]
b. 10 Jan 1888 d. 20 Feb 1924 [
=>
]
12
Amy Louisa Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.5.5]
b. 21 Sep 1890 d. 27 Mar 1972 [
=>
]
12
Delilah Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.5.6]
b. 16 Oct 1893 d. 25 Oct 1976 [
=>
]
12
Stanley Dean Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.5.7]
b. 13 Nov 1896 d. 25 Nov 1896
12
Leon Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.5.8]
b. 14 Jul 1899 d. 17 Jul 1966 [
=>
]
12
Vern George Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.5.9]
b. 10 Jan 1902 d. 9 May 1991
12
Kenneth Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.5.10]
b. 13 Jun 1904 d. 4 Apr 1973
11
Harriet Emily Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.6]
b. 21 Nov 1855 d. 4 Oct 1856
11
Annie Bard Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.7]
b. 5 Jun 1856
Susan Ann Gay
b. 13 Jun 1841 d. 29 Sep 1911
11
Martha Ellen Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.8]
b. 19 Jan 1858 d. 20 Oct 1937
Jacob Kesler
b. 30 Sep 1860 d. 25 Dec 1937
12
Hazel Gay Kesler
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.8.1]
b. 2 Apr 1884 d. 20 Dec 1956 [
=>
]
12
Essie Parthenia Kesler
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.8.2]
b. 23 Oct 1885 d. 29 Jul 1935
12
Frederick Nelson Kesler
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.8.3]
b. 22 Oct 1888 d. 13 Nov 1898
12
Dela Von Kesler
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.8.4]
b. 22 Feb 1890 d. 17 Jul 1934
12
Audrey Kesler
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.8.5]
b. 8 Jun 1893 d. 20 Apr 1897
12
Jacob Waldemar Kesler
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.8.6]
b. 23 Jan 1896 d. 8 Feb 1896
12
Martha Ellen Kesler
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.8.7]
b. 10 Sep 1897
11
Nelson Gay Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.9]
b. 21 Sep 1859 d. 2 Apr 1944
Susannah Wanless
b. 25 Apr 1866 d. 5 Jun 1949
12
William Nelson Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.9.1]
b. 22 Dec 1884 d. 30 May 1972 [
=>
]
12
John Gay Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.9.2]
b. 12 May 1887 d. 25 Jan 1949
12
James Anor Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.9.3]
b. 24 Feb 1889 d. 23 Jun 1946 [
=>
]
12
Raymond Leigh Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.9.4]
b. 17 May 1892 d. 9 Sep 1940
12
Marvian Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.9.5]
b. 11 Sep 1896 d. 26 Aug 1898
12
Frederick Dale Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.9.6]
b. 18 Mar 1908 d. 2 Oct 1960
11
Sylvia Gay Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.10]
b. 18 May 1862 d. 20 Jan 1940
Frederick Bateman Margetts
b. 9 Oct 1861 d. 7 Feb 1950
12
Fred Lynn Margetts
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.10.1]
b. 25 Sep 1885 d. 7 Jan 1971
12
Dora Estella Margetts
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.10.2]
b. 5 Mar 1887 d. 24 Jan 1963 [
=>
]
12
Paul Gay Margetts
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.10.3]
b. 12 Dec 1889 d. 6 Apr 1982 [
=>
]
12
Lucille Margetts
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.10.4]
b. 4 Mar 1893 d. 29 Oct 1959
12
Amy Jane Margetts
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.10.5]
b. 4 Oct 1895 d. 19 Feb 1952
12
Susan Ann Margetts
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.10.6]
b. 30 Mar 1898 d. 10 Oct 1995 [
=>
]
12
Anor Whipple Margetts
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.10.7]
b. 28 Feb 1900 d. 15 Apr 1969 [
=>
]
12
Nelson Whipple Margetts
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.10.8]
b. 2 Sep 1903 d. 20 Sep 1962 [
=>
]
11
Susan Ann Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.11]
b. 3 Nov 1864 d. 19 Dec 1935
Archer Walters Clayton
b. 10 Apr 1858 d. 27 Oct 1947
12
Archer Lynne Clayton
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.11.1]
b. 7 Jul 1883 d. 14 Oct 1952 [
=>
]
12
Don Carlos Clayton
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.11.2]
b. 15 Jan 1885 d. 14 Oct 1964 [
=>
]
12
Phyllis Clayton
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.11.3]
b. 29 Jun 1887 d. 13 Aug 1962 [
=>
]
12
Daughter Clayton
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.11.4]
b. 1889
12
Susan Ann Clayton
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.11.5]
b. 24 Dec 1891 d. 8 Jul 1977 [
=>
]
12
Alonzo Hyde Clayton
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.11.6]
b. 25 Apr 1893 d. 12 Apr 1984 [
=>
]
12
Ruth Clayton
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.11.7]
b. 16 Aug 1895 d. 12 May 1896
12
William Arthur Clayton
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.11.8]
b. 30 Aug 1897 d. 28 Jan 1980 [
=>
]
11
Alexander Samuel Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.12]
b. 2 Mar 1867 d. 8 Jan 1899
Sarah "Daisy" Van Natta
b. 8 May 1870 d. 18 Apr 1962
12
Mary Irene Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.12.1]
b. 16 Oct 1891 d. 5 Mar 1989 [
=>
]
12
Ida Jane Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.12.2]
b. 28 Jun 1894 d. 20 Feb 1968
11
Robert John Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.13]
b. 13 Nov 1869 d. 6 Nov 1954
Susie Winn
b. 10 Feb 1874 d. 8 Sep 1963
12
Ora Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.13.1]
b. 6 May 1897 d. 28 Apr 1956
12
Winnie Leath Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.13.2]
b. 21 Sep 1899 d. 23 Jun 1997 [
=>
]
12
Essie June Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.13.3]
b. 27 Jun 1902 d. 3 Jan 1984 [
=>
]
12
Byron John Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.13.4]
b. 15 Mar 1905 d. 19 Aug 1994 [
=>
]
12
Mildred Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.13.5]
b. 16 Nov 1907 d. 7 May 1987
12
Miriam Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.13.6]
b. 16 Nov 1907 d. 29 Jan 1981 [
=>
]
11
Amey Jane Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.14]
b. 15 Dec 1871 d. 6 Sep 1962
John Henry Evans
b. 29 Apr 1872 d. 24 Mar 1947
12
Emerson Whipple Evans
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.14.1]
b. 7 Apr 1901 d. 26 Mar 1973 [
=>
]
12
Alexander Whipple Evans
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.14.2]
b. 4 Aug 1902 d. 20 Apr 1954 [
=>
]
12
John Henry Evans, Jr
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.14.3]
b. 27 Jan 1903 d. 23 Jun 1988 [
=>
]
12
Gwendolyn Whipple Evans
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.14.4]
b. 2 Feb 1904 d. 21 Sep 1986 [
=>
]
12
Amy Evans
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.14.5]
b. 14 Feb 1909 d. 26 Dec 2001
12
Daughter Evans
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.14.6]
b. 20 Sep 1914 d. 20 Sep 1914
11
Ida Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.15]
b. 15 Dec 1873 d. 21 May 1956
Ezra Oakley Taylor
b. 20 May 1863 d. 19 Jul 1952
12
Mary Whipple Taylor
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.15.1]
b. 11 Feb 1897 d. 16 Apr 1953
12
Julia Whipple Taylor
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.15.2]
b. 6 Aug 1900 d. 27 Apr 1989 [
=>
]
12
Ezra Whipple Taylor
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.15.3]
b. 25 May 1904 d. 21 Jul 2001 [
=>
]
12
Ida Gay Taylor
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.15.4]
b. 19 Oct 1908 d. 23 Dec 2001
12
Irvin Whipple Taylor
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.15.5]
b. 16 Jul 1911 d. 4 Jul 1991 [
=>
]
12
Patricia Taylor
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.15.6]
b. 17 Mar 1919 d. 27 Sep 1997
11
Anor Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.16]
b. 25 Mar 1879 d. 23 Oct 1967
Aurilla May Watkins
b. 4 May 1884 d. 18 Apr 1976
12
Aurilla Gay Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.16.1]
b. 20 Aug 1918 d. 5 Mar 2011 [
=>
]
12
Roswell Watkins Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.16.2]
b. 4 Dec 1922 d. 1 Feb 2008
12
Helen Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.16.3]
b. 5 Feb 1926 d. 6 May 2009
Rachel Keeling
b. 10 Mar 1818 d. 16 Jun 1910
11
Daniel Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.17]
b. 12 Apr 1854 d. 12 Feb 1926
Ellen Hirst
b. 3 Feb 1862 d. 21 Dec 1935
12
Daniel LeRoy Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.17.1]
b. 28 Jul 1879 d. 7 Aug 1935 [
=>
]
12
George Wheeler Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.17.2]
b. 4 Aug 1881 d. 30 Sep 1965 [
=>
]
12
John Ernest Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.17.3]
b. 19 Feb 1883 d. 25 Jan 1946
12
Ella Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.17.4]
b. 27 Jan 1884 d. 29 Sep 1935 [
=>
]
12
Leonard Hirst Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.17.5]
b. 7 Jan 1887 d. 11 Nov 1970 [
=>
]
12
Orley Keeling Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.17.6]
b. 6 Apr 1895 d. 24 Sep 1962 [
=>
]
12
Eugene Brook "Dean" Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.17.7]
b. 29 Dec 1899 d. 31 May 1968 [
=>
]
11
Cynthia Delight Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.18]
b. 7 Jun 1857 d. 4 Sep 1858
11
Nelson Wheeler Whipple, Jr
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.19]
b. 15 Apr 1859 d. 30 Jun 1938
Mary Roberts
b. 15 Jul 1857 d. 23 Sep 1935
12
John Wheeler Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.19.1]
b. 19 Oct 1881 d. 3 Aug 1954 [
=>
]
12
Mable Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.19.2]
b. 4 Jul 1883 d. 8 Oct 1951 [
=>
]
12
Rachel Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.19.3]
b. 20 Dec 1885 d. 1 Jul 1886
12
Nelson Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.19.4]
b. 13 Mar 1887 d. 13 Mar 1887
12
Adelaide Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.19.5]
b. 5 May 1888 d. 21 Feb 1898
12
Lawrence Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.19.6]
b. 24 Sep 1891 d. 2 Apr 1934
12
Lillie May Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.19.7]
b. 6 May 1894 d. 20 Dec 1983 [
=>
]
12
Leslie Whipple
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.7.19.8]
b. 1 Oct 1898 d. Oct 1957 [
=>
]
Zenos Aldrich
b. Abt 1773 d. 8 Nov 1856
10
Sylvanus Aldrich
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.8]
b. 1799 d. 8 Nov 1856
10
Azuba Aldrich
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.9]
b. Abt 1801
Armstrong Baskins
b. 3 Apr 1786 d. 27 May 1842
11
Sarah Ann Baskins
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.9.1]
b. Abt 1824
11
Harriet N Baskins
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.9.2]
b. Abt 1830
11
Mary Jane Baskins
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.9.3]
b. 1832 d. 22 Dec 1850
11
Erastus Baskins
[1.3.1.4.2.1.7.4.9.9.4]
b. 1834 d. 3 Nov 1862
9
Azuba Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.10]
b. 22 Aug 1779 d. 13 Nov 1865
Jared Patchen
b. 5 Sep 1773 d. 1 May 1857
10
Martin Ray Patchen
[1.3.1.4.2.1.7.4.10.1]
b. 10 Feb 1799 d. 7 Feb 1842
10
Abigail Patchen
[1.3.1.4.2.1.7.4.10.2]
b. 23 Jan 1801 d. 7 Sep 1823
10
Emily Patchen
[1.3.1.4.2.1.7.4.10.3]
b. 1802 d. 16 Jul 1826
10
John Patchen
[1.3.1.4.2.1.7.4.10.4]
b. 14 Jan 1803 d. 23 Oct 1874
10
Ira Patchen
[1.3.1.4.2.1.7.4.10.5]
b. 10 Jun 1805
10
Polly Patchen
[1.3.1.4.2.1.7.4.10.6]
b. 20 Jan 1808 d. 21 Aug 1891
10
Mary Patchen
[1.3.1.4.2.1.7.4.10.7]
b. 20 Jan 1808 d. 23 Feb 1888
10
Jared Patchen
[1.3.1.4.2.1.7.4.10.8]
b. 6 Sep 1812
10
Sylvanus Aldridge Patchen
[1.3.1.4.2.1.7.4.10.9]
b. 27 Nov 1814 d. 10 Feb 1892
10
Azuba Ann Patchen
[1.3.1.4.2.1.7.4.10.10]
b. 4 Jun 1817 d. 29 Sep 1886
10
Hannah Lavinia Patchen
[1.3.1.4.2.1.7.4.10.11]
b. 24 Apr 1820
10
Samuel Lorenzo Patchen
[1.3.1.4.2.1.7.4.10.12]
b. 1 Aug 1823 d. 14 Jun 1867
10
Amy Patchen
[1.3.1.4.2.1.7.4.10.13]
b. Abt 5 Jul 1825
9
Phoebe Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.11]
b. 22 Aug 1781 d. 31 Dec 1855
Nathan S Stewart
b. 7 Mar 1771 d. 7 Aug 1866
10
Horace S Stewart
[1.3.1.4.2.1.7.4.11.1]
b. 15 Jun 1804 d. 7 Aug 1866
10
Erastus A Stewart
[1.3.1.4.2.1.7.4.11.2]
b. 10 Mar 1805 d. 10 Nov 1851
10
Elijah Burr Stewart
[1.3.1.4.2.1.7.4.11.3]
b. Abt 1809 d. 9 Nov 1880
10
Azuba Ann Stewart
[1.3.1.4.2.1.7.4.11.4]
b. 1810
10
Samuel Curtis Stewart
[1.3.1.4.2.1.7.4.11.5]
b. 1811 d. 25 Nov 1870
10
William Stewart
[1.3.1.4.2.1.7.4.11.6]
b. 1812
10
Azubam Stewart
[1.3.1.4.2.1.7.4.11.7]
b. 1812
10
Thomas Ryler Stewart
[1.3.1.4.2.1.7.4.11.8]
b. 1815
9
Amy Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.4.12]
b. 8 Dec 1783 d. 17 Dec 1857
Isaac Darrow
b. Abt 1779
10
John Tiffany Darrow
[1.3.1.4.2.1.7.4.12.1]
b. 17 Nov 1800 d. 13 Nov 1897
10
Affa Ward Darrow
[1.3.1.4.2.1.7.4.12.2]
b. 26 Dec 1803 d. 15 Apr 1875
10
Hannah Mead Darrow
[1.3.1.4.2.1.7.4.12.3]
b. 24 Apr 1806
10
Mary Cromwell Darrow
[1.3.1.4.2.1.7.4.12.4]
b. 9 May 1808 d. 18 Nov 1877
10
Ann Hubbard Darrow
[1.3.1.4.2.1.7.4.12.5]
b. 27 Mar 1811 d. 24 Jul 1890
10
Susan Pardee Darrow
[1.3.1.4.2.1.7.4.12.6]
b. 1813 d. 24 Jun 1890
8
Humphery Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.5]
b. 2 Mar 1742 d. 1831
Phebe Brown
b. Abt 1751 d. 1831
9
Lydia "Lidda" Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.5.1]
b. 13 May 1772 d. 1 Jul 1856
9
Susanna Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.5.2]
b. 28 Feb 1774
9
John C Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.5.3]
b. 17 Dec 1776 d. 9 Jul 1855
9
William Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.5.4]
b. Abt 1781 d. 12 Oct 1866
9
Phebe Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.5.5]
b. 1783
9
Humphrey Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.5.6]
b. 13 Sep 1788 d. 24 Jun 1870
9
Nelson Tiffany
[1.3.1.4.2.1.7.5.7]
b. 13 Sep 1808 d. 7 Sep 1869
7
Mary Comstock
[1.3.1.4.2.1.8]
b. Abt 1710
Nathan Beckwith
b. 22 Feb 1717 d. 24 Dec 1747
8
Mary Beckwith
[1.3.1.4.2.1.8.1]
b. Abt 1740 d. 10 Sep 1834
8
Ransom Beckwith
[1.3.1.4.2.1.8.2]
b. 12 Aug 1747
7
Samuel Comstock
[1.3.1.4.2.1.9]
b. Abt 1712 d. 1787
6
Moses Noyes
[1.3.1.4.2.2]
b. 1 Aug 1678 d. 10 Oct 1743
Mary Ely
b. 29 Nov 1689 d. 3 Feb 1764
7
Ruth Noyes
[1.3.1.4.2.2.1]
b. 1722 d. 14 May 1725
7
Moses Noyes
[1.3.1.4.2.2.2]
b. 1 Sep 1714 d. 23 Jul 1753
7
Ruth Noyes
[1.3.1.4.2.2.3]
b. 6 Jan 1716 d. 5 Feb 1719
7
Elizabeth Noyes
[1.3.1.4.2.2.4]
b. 1730 d. 8 May 1819
Jabez Sill
b. 4 Aug 1722 d. 14 Mar 1795
8
Elizabeth Noyes Sill
[1.3.1.4.2.2.4.1]
b. 22 Oct 1750 d. 27 Apr 1812
8
Mary Sill
[1.3.1.4.2.2.4.2]
b. 11 Jul 1752 d. 22 Apr 1842
8
Naomi Sill
[1.3.1.4.2.2.4.3]
b. 28 Nov 1754 d. 1838
8
Esther Sill
[1.3.1.4.2.2.4.4]
b. 1755 d. 7 Aug 1817
8
Shadrach Sill
[1.3.1.4.2.2.4.5]
b. 12 Aug 1758 d. 3 Nov 1813
8
Moses Sill
[1.3.1.4.2.2.4.6]
b. Abt 1760 d. Aug 1850
8
Dr Elisha Noyes Sill
[1.3.1.4.2.2.4.7]
b. 1761 d. 24 May 1845
8
Jabez Sill, Jr
[1.3.1.4.2.2.4.8]
b. 6 Mar 1763 d. 29 Jul 1838
8
Amasa Sill
[1.3.1.4.2.2.4.9]
b. 8 Jan 1767 d. 1772
8
Sarah Sill
[1.3.1.4.2.2.4.10]
b. 11 Oct 1770 d. 1779
7
William Noyes
[1.3.1.4.2.2.5]
b. 1735 d. 11 Feb 1807
Eunice Marvin
b. 2 Dec 1735 d. 5 Apr 1816
8
John Noyes
[1.3.1.4.2.2.5.1]
b. 18 Dec 1756 d. 1808
8
Captain Joseph Noyes
[1.3.1.4.2.2.5.2]
b. 1758 d. 1820
8
William Noyes
[1.3.1.4.2.2.5.3]
b. 30 Oct 1760 d. 23 Dec 1834
8
Matthew Noyes
[1.3.1.4.2.2.5.4]
b. 26 Feb 1764 d. 25 Sep 1839
6
Ruth Noyes
[1.3.1.4.2.3]
b. 6 Jan 1680 d. 5 May 1774
James Wadsworth
b. 1677 d. 1756
7
James Wadsworth
[1.3.1.4.2.3.1]
b. Abt 1700 d. 1777
Abigail Penfield
b. 22 Dec 1704 d. 1748
8
James Wadsworth
[1.3.1.4.2.3.1.1]
b. 8 Jul 1730 d. 22 Sep 1817
8
John Noyes Wadsworth
[1.3.1.4.2.3.1.2]
b. 1732 d. 1786
8
Ruth Wadsworth
[1.3.1.4.2.3.1.3]
b. 1743 d. 20 Jun 1813
Caleb Atwater
b. 7 Sep 1741 d. 19 Dec 1831
9
Anne Atwater
[1.3.1.4.2.3.1.3.1]
b. 17 Nov 1765
9
Joshua Atwater
[1.3.1.4.2.3.1.3.2]
b. Abt 1766
9
James Wadsworth Atwater
[1.3.1.4.2.3.1.3.3]
b. 30 Jun 1777 d. 30 Oct 1777
9
Abigail Atwater
[1.3.1.4.2.3.1.3.4]
b. 3 Dec 1778 d. 3 Sep 1834
9
Catharine Atwater
[1.3.1.4.2.3.1.3.5]
b. Abt 1780
9
Catherine "Kate" Atwater
[1.3.1.4.2.3.1.3.6]
b. 25 May 1781
9
Ruth Atwater
[1.3.1.4.2.3.1.3.7]
b. 11 Apr 1788 d. 2 Nov 1877
6
Sarah Noyes
[1.3.1.4.2.4]
b. 1682 d. 16 Aug 1756
Captain Timothy Mather
b. 20 Mar 1681 d. 25 Jul 1755
7
Timothy Mather
[1.3.1.4.2.4.1]
b. 9 Oct 1711
7
Joseph Mather
[1.3.1.4.2.4.2]
b. 23 Feb 1713 d. 5 Feb 1778
7
Ruth Mather
[1.3.1.4.2.4.3]
b. 3 Dec 1715 d. 4 Dec 1790
7
Catharine Mather
[1.3.1.4.2.4.4]
b. 1717 d. 4 Dec 1799
7
Moses Mather
[1.3.1.4.2.4.5]
b. 1718 d. 21 Sep 1806
6
John Noyes
[1.3.1.4.2.5]
b. 21 Jan 1688 d. 14 Feb 1755
Jane Dole
b. 23 Jan 1692 d. 14 Feb 1755
7
Josiah Noyes
[1.3.1.4.2.5.1]
b. 8 Sep 1712 d. 18 Feb 1796
7
Dorothy Noyes
[1.3.1.4.2.5.2]
b. 9 Apr 1715 d. 19 Mar 1798
7
Hannah Noyes
[1.3.1.4.2.5.3]
b. 6 Jul 1720 d. Bef Dec 1761
7
Jane Noyes
[1.3.1.4.2.5.4]
b. 8 Jan 1722
7
Oliver Noyes
[1.3.1.4.2.5.5]
b. 19 Mar 1724 d. 30 Apr 1725
7
Amos Noyes
[1.3.1.4.2.5.6]
b. 29 Jul 1728 d. 1752
7
Lieutenant colonel Peter Noyes
[1.3.1.4.2.5.7]
b. 3 Dec 1731 d. Aug 1796
5
John Pickett
[1.3.1.4.3]
b. 25 Jul 1656 d. 7 Oct 1687
Mary Cross
b. Abt 1646 bur. 7 Oct 1687
6
John Pickett
[1.3.1.4.3.1]
b. 5 Jan 1678 d. 9 Dec 1739
6
Mary Pickett
[1.3.1.4.3.2]
b. 1675 d. 10 Nov 1732
6
Rebecca Pickett
[1.3.1.4.3.3]
b. Dec 1673 d. 1693
5
Adam Pickett
[1.3.1.4.4]
b. 15 Nov 1658 d. 1691
Hannah Wetherell
b. 21 Mar 1659 d. 16 Sep 1689
6
Adam Pickett, Jr
[1.3.1.4.4.1]
b. 7 Sep 1681 d. 1709
6
John Pickett
[1.3.1.4.4.2]
b. 28 Jul 1685 d. 9 Dec 1738
6
Hannah Pickett
[1.3.1.4.4.3]
b. 6 Jun 1689
5
Mercy Pickett
[1.3.1.4.5]
b. 16 Jan 1660 d. 25 Nov 1728
Samuel Fosdick
b. 15 Dec 1655 d. 27 Aug 1702
6
Mercy Fosdick
[1.3.1.4.5.1]
b. 30 Nov 1686 d. 9 Jul 1754
6
Thomas Fosdick
[1.3.1.4.5.2]
b. Abt 1688 d. 1744
6
Samuel Fosdick
[1.3.1.4.5.3]
b. Abt 1681 d. 22 Feb 1753
6
Anna Fosdick
[1.3.1.4.5.4]
b. 8 Dec 1691 d. 13 Mar 1715
6
Ruth Fosdick
[1.3.1.4.5.5]
b. 27 Jan 1689 d. 29 Jun 1741
6
John Fosdick
[1.3.1.4.5.6]
b. 1 Feb 1694 d. 7 Feb 1747
5
William Pickett
[1.3.1.4.6]
b. 1662 d. 1690
Charles Hill
b. Abt 1636 d. Oct 1684
5
Jane Hill
[1.3.1.4.7]
b. 1669 d. 8 Jan 1711
5
Charles Hill
[1.3.1.4.8]
b. 16 Oct 1671 d. 1710
5
Ruth Hill
[1.3.1.4.9]
b. Oct 1673 d. 1674
5
Jonathan Hill
[1.3.1.4.10]
b. Dec 1674 d. 26 Feb 1724
5
Son Hill
[1.3.1.4.11]
b. 27 Apr 1677 d. 27 Apr 1677
4
Benjamin Brewster
[1.3.1.5]
b. 17 Oct 1633 d. 14 Sep 1710
Anne Addis
b. 17 Mar 1628 d. 9 May 1709
5
Mary Brewster
[1.3.1.5.1]
b. 10 Dec 1660 d. 2 Dec 1750
5
Ann Brewster
[1.3.1.5.2]
b. 29 Sep 1662 d. 30 Oct 1715
5
Jonathan Brewster
[1.3.1.5.3]
b. 30 Nov 1664 d. 26 Nov 1704
5
Daniel Brewster
[1.3.1.5.4]
b. 1 Mar 1666 d. 7 May 1735
5
William Brewster
[1.3.1.5.5]
b. 22 Mar 1669 d. 11 Aug 1728
5
Ruth Brewster
[1.3.1.5.6]
b. 16 Sep 1671 d. 22 Aug 1734
5
Benjamin Brewster
[1.3.1.5.7]
b. 25 Dec 1673 d. 31 Jan 1755
5
Elizabeth Brewster
[1.3.1.5.8]
b. 23 Jun 1676 d. 9 Mar 1744
4
Elizabeth Brewster
[1.3.1.6]
b. 1 May 1637 d. 11 Nov 1713
Christopher Christophers
b. 1631 d. 23 Jul 1687
5
John Christophers
[1.3.1.6.1]
b. 3 Sep 1668 d. 3 Feb 1703
5
Son Christophers
[1.3.1.6.2]
b. Abt 1670
5
Son Christophers
[1.3.1.6.3]
b. 1674
5
Hannah Christophers
[1.3.1.6.4]
b. 1675 d. 24 Oct 1738
Peter Bradley
b. 30 May 1613 d. 3 Apr 1662
5
Elizabeth Bradley
[1.3.1.6.5]
b. 16 Mar 1654
Thomas Dimond
b. Abt 1642 d. 1687
6
Elizabeth Dimond
[1.3.1.6.5.1]
b. 14 Aug 1672 d. 13 Apr 1752
6
Thomas Dimond
[1.3.1.6.5.2]
b. 22 Jul 1675 d. 18 Apr 1754
6
Moses Dimond
[1.3.1.6.5.3]
b. 14 May 1677
6
Ruth Dimond
[1.3.1.6.5.4]
b. 12 Sep 1680
6
John Dimond
[1.3.1.6.5.5]
b. 25 Jul 1685 d. 1687
5
Hannah Bradley
[1.3.1.6.6]
b. 17 Sep 1656 d. 1725
5
Peter Bradley
[1.3.1.6.7]
b. 7 Sep 1658 d. 25 Aug 1687
5
Lucretia Bradley
[1.3.1.6.8]
b. 16 Aug 1661 d. 7 Jan 1690
4
Grace Brewster
[1.3.1.7]
b. 1 Nov 1639 d. 22 Apr 1684
Captain Daniel Wetherell
b. 29 Nov 1630 d. 14 Apr 1719
5
Daniel Wetherell
[1.3.1.7.1]
b. 4 Aug 1659
5
Hannah Wetherell
[1.3.1.7.2]
b. 21 Mar 1659 d. 16 Sep 1689
Adam Pickett
b. 15 Nov 1658 d. 1691
6
Adam Pickett, Jr
[1.3.1.7.2.1]
b. 7 Sep 1681 d. 1709
6
John Pickett
[1.3.1.7.2.2]
b. 28 Jul 1685 d. 9 Dec 1738
6
Hannah Pickett
[1.3.1.7.2.3]
b. 6 Jun 1689
5
Marge Wetherell
[1.3.1.7.3]
b. 1662 d. 1662
5
Son Wetherell
[1.3.1.7.4]
b. Abt 1663 d. Abt 1663
5
Son Wetherell
[1.3.1.7.5]
b. Abt 1664 d. Abt 1664
5
Son Wetherell
[1.3.1.7.6]
b. Abt 1665 d. Abt 1665
5
Son Wetherell
[1.3.1.7.7]
b. Abt 1666 d. Abt 1666
5
Mary Brewster Wetherall
[1.3.1.7.8]
b. 7 Oct 1668 d. 22 May 1711
Thomas Harris
b. 20 May 1657 d. 9 Jun 1691
6
Thomas Harris
[1.3.1.7.8.1]
b. 3 Feb 1689 d. 24 Oct 1749
6
Mary Harris
[1.3.1.7.8.2]
b. 4 Nov 1690 d. 5 Mar 1725
George Denison
b. 28 Mar 1671 d. 20 Jan 1719
6
Grace Denison
[1.3.1.7.8.3]
b. 4 Mar 1695 d. 28 Nov 1748
6
Phebe Denison
[1.3.1.7.8.4]
b. 3 Mar 1696 d. 18 Feb 1761
6
Hannah Denison
[1.3.1.7.8.5]
b. 28 Mar 1699 d. 9 Apr 1782
6
Borodell Denison
[1.3.1.7.8.6]
b. 17 May 1701 d. 5 May 1751
6
Daniel Denison
[1.3.1.7.8.7]
b. 27 Jun 1703 d. 2 Feb 1748
6
Wetherell Denison
[1.3.1.7.8.8]
b. 24 Aug 1705 d. 29 Jan 1745
6
Anne Denison
[1.3.1.7.8.9]
b. 11 Aug 1707 d. 3 Aug 1787
6
Sarah Denison
[1.3.1.7.8.10]
b. 20 Jun 1710 d. 12 May 1796
5
Daniel Wetherell, Jr
[1.3.1.7.9]
b. 26 Jan 1670 d. 9 Oct 1679
5
Samuel Wetherell
[1.3.1.7.10]
b. Bef 19 Oct 1679
4
Hanna Brewster
[1.3.1.8]
b. 3 Nov 1641 d. 11 Dec 1711
Samuel Starr
b. 3 Nov 1641 d. 2 Feb 1687
5
Samuel Starr
[1.3.1.8.1]
b. 11 Dec 1665 d. 1687
5
Comfort Starr
[1.3.1.8.2]
b. 7 Aug 1671 d. Abt 1672
5
William Starr
[1.3.1.8.3]
b. 1675
5
Jonathan Starr
[1.3.1.8.4]
b. 23 Feb 1674 d. 26 Aug 1747
5
Thomas Starr
[1.3.1.8.5]
b. 27 Sep 1668 d. 13 Jan 1711
5
Mary Starr
[1.3.1.8.6]
b. Abt 1677
5
Rachel Starr
[1.3.1.8.7]
b. Abt 1679
5
James Starr
[1.3.1.8.8]
b. Abt 1681
+
Captain James Morgan
b. 3 Mar 1644 d. 8 Dec 1711
3
Patience Brewster
[1.3.2]
b. Abt 1600 d. 12 Dec 1634
Governor Thomas Prence, Jr
b. 1600 d. 29 Mar 1673
4
Rebecca Prence
[1.3.2.1]
b. 22 Mar 1627 d. 18 Jul 1651
4
Thomas Prence
[1.3.2.2]
b. 22 Mar 1627 d. Abt 13 Mar 1672
4
Mercy Prence
[1.3.2.3]
b. 28 Sep 1631 d. 28 Sep 1711
John Freeman
b. 28 Jan 1626 d. 28 Oct 1719
5
John Freeman
[1.3.2.3.1]
b. 2 Dec 1651 d. 27 Jul 1721
5
Thomas Freeman
[1.3.2.3.2]
b. 6 Sep 1653 d. 9 Feb 1715
5
Edmund Freeman
[1.3.2.3.3]
b. 3 Jun 1657 d. 11 Feb 1719
5
Mercy Freeman
[1.3.2.3.4]
b. 23 Jun 1659 d. 19 Jun 1744
5
William Freeman
[1.3.2.3.5]
b. 1662 d. 31 May 1687
5
Hannah Freeman
[1.3.2.3.6]
b. 1664 d. 15 Feb 1743
John Mayo
b. 1655 d. 1 Feb 1725
6
Samuel Mayo
[1.3.2.3.6.1]
b. 16 Jul 1684 d. 7 Oct 1761
6
Mercy Mayo
[1.3.2.3.6.2]
b. 23 Apr 1688 d. 25 Mar 1765
6
John Mayo
[1.3.2.3.6.3]
b. 10 May 1691 d. 1 Feb 1756
6
Rebecca Mayo
[1.3.2.3.6.4]
b. 18 Sep 1692 d. Aft 17 Jun 1762
6
Mary Mayo
[1.3.2.3.6.5]
b. 26 Oct 1694 d. 15 Jan 1771
6
Joseph Mayo
[1.3.2.3.6.6]
b. 22 Dec 1696 d. Aft 3 Sep 1773
6
Elizabeth Mayo
[1.3.2.3.6.7]
b. 16 Jul 1706 d. 27 Feb 1789
Ebenezer Nickerson
b. 13 Jun 1697 d. 15 Feb 1768
7
Mary Nickerson
[1.3.2.3.6.7.1]
b. 3 Aug 1727 d. Bef 1730
7
Hannah Nickerson
[1.3.2.3.6.7.2]
b. 23 Oct 1728
7
Mary Nickerson
[1.3.2.3.6.7.3]
b. 14 Jul 1730 d. 26 Mar 1807
7
Elizabeth Nickerson
[1.3.2.3.6.7.4]
b. 8 Aug 1732 d. Bef 1808
7
Ebenezer Nickerson
[1.3.2.3.6.7.5]
c. 13 Jan 1734 d. 8 Dec 1792
7
Mercy Nickerson
[1.3.2.3.6.7.6]
b. 29 Apr 1742 d. 1821
Nathaniel Hinckley
b. 25 Jun 1738 d. 29 May 1790
8
Deborah Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.1]
b. 30 Jan 1762 d. 27 Oct 1841
8
Lydia Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.2]
c. 9 Aug 1767
8
Isaac Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.3]
b. 25 Sep 1767
8
Nathaniel Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.4]
b. 12 Jul 1769 d. 22 Mar 1849
Rhoda Barber
b. 3 Feb 1773 d. Aug 1859
9
Silas Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.4.1]
b. 1 Jun 1793 d. 22 Mar 1807
9
Erastus Nathaniel Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.4.2]
b. 5 Dec 1794 d. 8 Sep 1831
Lois Judd
b. 15 Apr 1805 d. 4 Jun 1842
10
Levi Silas Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.4.2.1]
b. 12 Oct 1821 d. 1864
10
Harvey Judd Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.4.2.2]
b. 19 Jul 1823 d. 29 Feb 1892
10
Arza Erastus Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.4.2.3]
b. 15 Aug 1826 d. 18 Feb 1901
10
Ira Nathaniel Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.4.2.4]
b. 31 Oct 1828 d. 10 Apr 1904
Angeline Wilcox Noble
b. 26 Oct 1831 d. 28 Apr 1912
11
Emily Angeline Jean Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.4.2.4.1]
b. 31 Mar 1856 d. 17 Feb 1947
11
Laverna Noble Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.4.2.4.2]
b. 23 Nov 1858 d. 9 Sep 1935
11
Ira Noble Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.4.2.4.3]
b. 24 Nov 1860 d. 14 Dec 1942
Lillian King
b. 26 Apr 1864 d. 13 Sep 1948
12
Daughter Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.4.2.4.3.1]
b. 5 Aug 1887 d. 10 May 1978
12
Ira Parnell Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.4.2.4.3.2]
b. 22 Apr 1889 d. 18 Nov 1984 [
=>
]
12
Samuel Lawrence Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.4.2.4.3.3]
b. 1 Feb 1891 d. 8 Jan 1968
12
Hortense Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.4.2.4.3.4]
b. 9 Apr 1894 d. 30 Jan 1958
12
Lillian Jean Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.4.2.4.3.5]
b. 4 Feb 1896 d. 30 Sep 1897
12
Daughter Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.4.2.4.3.6]
b. 30 Mar 1898 d. 19 Sep 1927
12
Gwendolyn Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.4.2.4.3.7]
b. 4 Jul 1900 d. 4 Feb 1963
12
Clara Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.4.2.4.3.8]
b. 24 Sep 1902 bur. 9 Oct 1999
12
Edith Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.4.2.4.3.9]
b. 4 Jan 1905 d. 26 Jun 1971
11
Amelia Clarisa Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.4.2.4.4]
b. 18 Aug 1863 d. 10 Nov 1865
11
Mary Noble Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.4.2.4.5]
b. 24 Dec 1865 d. 8 Aug 1866
11
Harvey Noble Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.4.2.4.6]
b. 24 Dec 1865 d. 10 Nov 1866
11
Bryant Stringham Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.4.2.4.7]
b. 9 Jul 1867 d. 5 Jun 1961
Christene Johnson
b. 4 Jun 1870 d. 11 Jul 1908
12
Bryant Stanford Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.4.2.4.7.1]
b. 10 Jul 1894 d. 19 Oct 1918
12
Josephine Lucile Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.4.2.4.7.2]
b. 2 Apr 1896 d. 2 Jun 1973
12
Heber Grant Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.4.2.4.7.3]
b. 16 Dec 1898 d. 18 Jan 1974
12
Grace Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.4.2.4.7.4]
b. Abt Jul 1899 d. 23 Jan 1902
12
Caroline Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.4.2.4.7.5]
b. 23 Jan 1902 d. 27 Aug 1995
12
Ralph Waldo Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.4.2.4.7.6]
b. 1 Feb 1904 d. 12 Apr 1982
12
Wendell Johnson Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.4.2.4.7.7]
b. 1 Feb 1904 d. 27 Jan 1927
12
Virginia Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.4.2.4.7.8]
b. 25 Oct 1905 d. 25 Oct 1905
12
Venice Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.4.2.4.7.9]
b. 25 Oct 1905 d. 14 Jun 1987
12
Christine Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.4.2.4.7.10]
b. 11 May 1908 d. 2 Jul 1991
Ada Bitner
b. 30 Jun 1880 d. 9 Nov 1930
12
Gordon Bitner Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.4.2.4.7.11]
b. 23 Jun 1910 d. 27 Jan 2008 [
=>
]
12
Sherman Bitner Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.4.2.4.7.12]
b. 20 Oct 1911 d. 13 Aug 2000
12
Ruth Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.4.2.4.7.13]
b. 3 Feb 1914 d. 13 Sep 1982
12
Ramona Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.4.2.4.7.14]
b. 31 Jan 1916 d. 5 Sep 2011
12
Sylvia Bitner Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.4.2.4.7.15]
b. 7 Mar 1920 d. 2 Feb 1970
+
May Green
b. 1 May 1881 d. 2 May 1943
+
Lois Anderson
b. 6 Nov 1889 d. 7 May 1983
11
Alonzo Arza Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.4.2.4.8]
b. 23 Apr 1870 d. 22 Dec 1936
11
Elmer Eugene Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.4.2.4.9]
b. 28 Dec 1872 d. 17 Oct 1954
Helen Angie Callister
b. 9 Jun 1878 d. 29 Aug 1915
12
Eugene Callister Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.4.2.4.9.1]
b. 15 Aug 1899 d. 31 Mar 1974
12
Alice Angeline Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.4.2.4.9.2]
b. 12 Jun 1901 d. 4 Dec 1982
12
Virginia Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.4.2.4.9.3]
b. 28 Mar 1912 d. 26 Sep 1996
10
Rhoda Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.4.2.5]
b. 5 Apr 1830 d. 6 Mar 1837
9
Levi Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.4.3]
b. 4 Apr 1797 d. 18 Sep 1863
9
Rhoda Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.4.4]
b. 12 Oct 1799
9
Polly Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.4.5]
b. 6 Dec 1802 d. 8 Sep 1831
9
Harvey Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.4.6]
b. 6 Nov 1804 d. 17 Jun 1875
9
Silas Barnard Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.4.7]
b. 6 Dec 1811 d. 15 Dec 1859
8
Thomas Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.5]
b. 15 Jul 1773 d. Abt 1814
8
Rachel Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.6]
b. 2 Oct 1776
8
Elijah Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.7]
b. 18 Jan 1783 d. 7 Sep 1846
8
Mark Snow Hinckley
[1.3.2.3.6.7.6.8]
c. 30 Jun 1765
7
Elijah Nickerson
[1.3.2.3.6.7.7]
b. 19 Oct 1748 d. 17 Mar 1823
5
Prence Freeman
[1.3.2.3.7]
b. 3 Feb 1665 d. 1747
5
Patience Freeman
[1.3.2.3.8]
b. 1667 d. 15 Feb 1744
5
Nathaniel Freeman
[1.3.2.3.9]
b. 20 Mar 1669 d. 9 Jan 1760
4
Hannah Prence
[1.3.2.4]
b. 1632/1633 d. Bef 23 Nov 1698
3
Fear Brewster
[1.3.3]
b. Abt 1606 d. 12 Dec 1634
Isaac Allerton
b. Abt 1586 d. 12 Feb 1659
4
Sarah Allerton
[1.3.3.1]
b. 22 May 1627 d. 12 Sep 1655
+
Thomas Cushman
4
Isaac Allerton
[1.3.3.2]
b. 11 May 1628 d. 25 Oct 1702
Elizabeth Willoughby
b. 27 Sep 1635 d. Apr 1672
5
Elizabeth Allerton
[1.3.3.2.1]
b. 27 Sep 1653 d. 17 Nov 1740
Simon Eyres
b. 6 Aug 1652 d. 1695
6
Lidia Eyres
[1.3.3.2.1.1]
b. 17 Sep 1680
6
Sarah Eyres
[1.3.3.2.1.2]
b. 1681
6
Simon Eyres
[1.3.3.2.1.3]
b. 5 Sep 1682 d. 1695
6
Isaac Eyres
[1.3.3.2.1.4]
b. 23 Feb 1684 d. 1685
5
Isaac Allerton
[1.3.3.2.2]
b. 11 Jun 1655 d. 25 Oct 1702
Elizabeth
b. 1663
6
John Allerton
[1.3.3.2.2.1]
b. 1685 d. 1750
3
Son Brewster
[1.3.4]
b. Abt 1609 d. 20 Jun 1609
3
Love Brewster
[1.3.5]
b. Abt 1611 d. 31 Jan 1650
Sarah Collier
b. 30 Apr 1616 d. 26 Apr 1691
4
Sarah Brewster
[1.3.5.1]
b. Abt 1636 d. Oct 1678
Benjamin Bartlett
b. Bef 6 Jun 1633 d. Aug 1691
5
Benjamin Bartlett
[1.3.5.1.1]
b. 27 Jun 1658 d. Bef 10 Apr 1724
5
Samuel Bartlett
[1.3.5.1.2]
b. Abt 1662 d. Bef 9 Dec 1713
5
Rebecca Bartlett
[1.3.5.1.3]
b. Abt 1664 d. 14 Dec 1741
5
Ichabod Bartlett
[1.3.5.1.4]
b. Bef May 1674 d. 1 Jan 1716
4
Wrestling Brewster
[1.3.5.2]
b. 1644 d. 1 Jan 1695
4
Love Brewster
[1.3.5.3]
d. 1 Jan 1696
4
Deacon William Brewster
[1.3.5.4]
b. 9 Mar 1645 d. 3 Nov 1723
Lydia Partridge
b. Abt 1650 d. 2 Feb 1743
5
Nathaniel Brewster
[1.3.5.4.1]
b. 8 Nov 1679 d. 1755
5
Lydia Brewster
[1.3.5.4.2]
b. 11 Feb 1680
Job Cushman
b. Abt 1666 d. 21 May 1740
6
Mariah Cushman
[1.3.5.4.2.1]
b. 16 Feb 1706 d. 1754
6
Job Cushman
[1.3.5.4.2.2]
b. 20 Feb 1710 d. 12 Nov 1729
6
Lydia Cushman
[1.3.5.4.2.3]
b. 31 Oct 1718 d. 10 Nov 1773
5
William Brewster, Jr
[1.3.5.4.3]
b. 4 May 1683 d. 26 Dec 1768
5
Mary Brewster
[1.3.5.4.4]
b. 7 Dec 1685 d. 1746
5
Benjamin Brewster
[1.3.5.4.5]
b. 7 Dec 1685 d. 7 Nov 1752
5
Joseph Brewster
[1.3.5.4.6]
b. 17 Mar 1693 d. 20 Apr 1767
5
Sarah Brewster
[1.3.5.4.7]
b. 4 Aug 1694 d. 1 Jan 1767
5
Joshua Brewster
[1.3.5.4.8]
b. 1698 d. 27 Mar 1776
3
Wrestling Brewster
[1.3.6]
b. Abt 1614 d. 22 May 1627
2
Edward Brewster
[1.4]
b. 1568 d. 14 Jan 1613
2
James Brewster
[1.5]
b. 1568 d. 14 Jan 1613
Mary Wellbeck
b. 1570 d. 7 Apr 1637
3
Ann Brewster
[1.5.1]
b. 1593
3
Grace Brewster
[1.5.2]
b. 1600
3
Elizabeth Brewster
[1.5.3]
b. 1602 d. 1603
3
Susanna Brewster
[1.5.4]
b. 1606
3
Judith Brewster
[1.5.5]
b. 1609