Home Page
|
What's New
|
Photos
|
Histories
|
Headstones
|
Reports
|
Surnames
Search
First Name:
Last Name:
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Suomalainen
Svenska
John Black
Abt 1565 -
Submit Photo / Document
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Submit Photo / Doc
Worksheet
Family
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
John Black
[1]
b. Abt 1565
Elizabeth Locart
b. 1570 d. 1641
2
John Black
[1.1]
b. Abt 1613 d. 1 Mar 1675
Susanna Freeman
b. Abt 1610 d. Aft 1645
3
Persis Black
[1.1.1]
b. Abt 1627 d. 20 Jul 1677
William Follett
b. Abt 1625
4
Susanna Follett
[1.1.1.1]
b. 1 Jun 1662
Joseph Sibley
b. 1655 d. 25 Apr 1711
5
Joseph Sibley
[1.1.1.1.1]
b. 9 Nov 1685 d. 1754
Elizabeth Boutwell
b. 2 Mar 1683 d. Bef 1734
6
Joseph Sibley
[1.1.1.1.1.1]
b. 6 Mar 1709 d. 22 Aug 1777
6
John Sibley
[1.1.1.1.1.2]
b. 2 Aug 1711 d. 27 Nov 1778
6
James Sibley
[1.1.1.1.1.3]
b. 7 May 1714
6
Elizabeth Sibley
[1.1.1.1.1.4]
b. Abt 1716
6
Jonathan Sibley
[1.1.1.1.1.5]
b. 11 Sep 1718 d. 30 Mar 1787
6
Hannah Sibley
[1.1.1.1.1.6]
b. 27 Jun 1721
6
Susanna Sibley
[1.1.1.1.1.7]
b. 24 Aug 1723
6
Mary Sibley
[1.1.1.1.1.8]
b. 23 Sep 1725
5
John Sibley
[1.1.1.1.2]
b. 18 Sep 1687 d. 13 May 1741
Zerviah Gould
b. 20 Apr 1694 d. Bef 1741
6
Ebenezer Sibley
[1.1.1.1.2.1]
b. 28 Feb 1717 d. 4 Mar 1790
Abigail Cummings
b. 3 May 1716 d. 27 Sep 1783
7
Stephen Sibley
[1.1.1.1.2.1.1]
b. 12 Jul 1741 d. 25 Aug 1828
Thankful Taft
b. 25 May 1745 d. 26 Oct 1837
8
Joel Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1]
b. 25 Apr 1766 d. 10 Apr 1839
Lois Louise Woods
b. 24 Jun 1767 d. 21 Nov 1832
9
Amory Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.1]
b. 20 Jun 1792 d. 22 Jun 1849
Caroline Bosworth
b. Abt 1796 d. 13 Jan 1858
10
Martha Elmira Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.1.1]
b. 16 Oct 1839 d. 1 Oct 1920
Harriss de Antignac
b. 7 Oct 1837 d. 22 Jan 1909
11
Caroline de Antignac
[1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1]
b. 9 Aug 1857 d. 11 Dec 1934
Wilbur Rogers
b. 13 Dec 1857 d. 20 Dec 1933
12
Harriss de Antignac
[1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1]
b. 2 Oct 1893 d. 22 Sep 1947
9
Josiah Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2]
b. 1 Apr 1808 d. 7 Dec 1888
Sarah Ann Sophia Crapon
b. 24 Oct 1809 d. 17 May 1858
10
Samuel Hale Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.1]
b. 9 Sep 1835 d. 1883
Sarah Virginia Hart
b. 22 Oct 1846 d. 3 Jun 1917
11
Josiah Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.1.1]
b. 1866 d. 1879
11
Grace Pendleton Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.1.2]
b. 1868 d. 1870
11
Jennie Hart Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.1.3]
b. 28 Dec 1869
11
Kate Collier Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.1.4]
b. 1872 d. 1921
11
Samuel Hale Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.1.5]
b. 12 Jul 1873 d. 13 Oct 1958
Florence Weldon Hart
b. 1 Sep 1875 d. 16 Nov 1941
12
William Hart Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.1.5.1]
b. 4 Aug 1898 d. Sep 1972
12
Lucy Bentley Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.1.5.2]
b. 22 Jun 1900 d. 1900
12
Sarah Virginia Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.1.5.3]
b. 9 Aug 1901 d. 19 Jun 1984 [
=>
]
12
Florence Weldon Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.1.5.4]
b. 20 Aug 1906 d. Apr 1982
11
James Hart Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.1.6]
b. 1875
10
William Crapon Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2]
b. 3 May 1832 d. 17 Apr 1902
Jane Elizabeth Thomas
b. 13 Feb 1838 d. 21 Apr 1930
11
Anne Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.1]
b. 11 Mar 1862 d. Jun 1863
11
Josiah Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.2]
b. 19 Jan 1864 d. 11 Aug 1866
11
Grigsby Thomas Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.3]
b. 21 Dec 1865 d. 1 Aug 1954
Mary Smith
b. Abt 1868
12
Hinson Smith Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.3.1]
b. 1888 [
=>
]
12
Jennifer Thomas Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.3.2]
b. 10 Jan 1889 d. Aft 1920
12
Rosina Fisher Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.3.3]
b. 30 Aug 1890 d. Jul 1975
12
Anne Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.3.4]
b. Dec 1893
12
Mary Smith Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.3.5]
b. Nov 1895
12
Grace Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.3.6]
b. 23 Oct 1897 d. 15 Jul 1986
12
Lilian Pearl Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.3.7]
b. 1901
12
Grigsby Thomas Sibley, Jr
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.3.8]
b. 2 Mar 1906 d. 17 Aug 1979
11
Barney Dunbar Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.4]
b. 18 Oct 1870 d. 5 Sep 1946
Caroline Carrie Harris
b. Jun 1873 d. 11 Nov 1958
12
Margarite Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.2.4.1]
b. Aug 1895
10
Henry Josiah Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.3]
b. 19 Nov 1833 d. 25 Jul 1864
10
Sophia Matilda Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.4]
b. 16 Oct 1837 d. 29 Oct 1897
+
Charles E Smedes
10
George Royal Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.5]
b. 19 Jul 1839 d. 15 Jul 1895
Emma Susan Hansel Tucker
b. 20 May 1845 d. 1911
11
Alice Reese Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.5.1]
b. 18 Feb 1863
Asbury Hull
b. 3 Feb 1860 d. 16 Oct 1901
12
Emma Georgia Hull
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.5.1.1]
b. 6 Nov 1883 d. 1929
12
Jep Rucker Hull
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.5.1.2]
b. 8 Oct 1888
12
Alice Sibley Hull
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.5.1.3]
b. 13 Aug 1891
12
Asbury Hull
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.5.1.4]
b. 10 Jan 1894 d. 7 Feb 1902
11
Mary Lois Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.5.2]
b. Feb 1870
11
Annabelle Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.5.3]
b. Sep 1882
11
George Royal Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.5.4]
b. 17 Jun 1884
10
Fannie Maria Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.6]
b. 13 Oct 1841 d. 20 Dec 1842
10
Mary Lois Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.7]
b. 3 Sep 1843 d. 23 Feb 1864
10
Alice Marie Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.8]
b. 9 Feb 1846 d. 13 Jul 1907
+
William T Williams
10
Robert Pendelton Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.9]
b. Abt 1847
Susan Wheless Bolling
b. 19 Jan 1851
11
Bolling Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.9.1]
b. 20 Aug 1873
+
Harriet Erle Beasley
b. 9 Dec 1882
11
Frances Wheless Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.9.2]
b. 2 Jan 1875
+
Maximillan H Lorenz
b. Abt 1870 d. Bef 1920
11
Josiah Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.9.3]
b. 12 May 1877
Adeline Webb
b. 31 May 1879
12
Lois Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.9.3.1]
b. 17 May 1914 d. 8 Feb 1988
12
Robert Peyton Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.9.3.2]
b. 7 Mar 1917 d. 7 Mar 1988
12
Josiah Sibley, Jr
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.9.3.3]
b. Abt 1920 d. 28 Mar 1966
11
George R Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.9.4]
b. 8 Feb 1879
+
Alice Maud Maynard
b. 1883
11
Robert Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.9.5]
b. 28 Mar 1881
+
Catharine Stone
b. 3 Sep 1882
11
Herbert Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.9.6]
b. 13 Oct 1885 d. Aug 1904
10
Caroline Crapon Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.10]
b. 21 Feb 1850 d. 16 Nov 1858
10
Amory Walter Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.11]
b. 19 Jun 1852 d. 28 Jul 1899
10
Josiah Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.12]
b. 1866 d. 1879
Emaline Eve
b. 1839
10
John Adam Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.13]
b. 1 Sep 1861 d. 26 Mar 1934
+
Sarah Louise Chandler
10
James Longstreet Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.14]
b. 4 Aug 1863 d. 10 Sep 1945
Martha Erwin
b. 1862 d. 22 Dec 1930
11
Martha Erwin Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.14.1]
b. 13 Feb 1886 d. 10 Aug 1975
Case
b. 1886
12
Dorothy Case
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.14.1.1]
b. 23 Aug 1909 d. 11 Apr 1911
11
John Adams Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.14.2]
b. 4 Jan 1888 d. 25 Oct 1986
+
Nettie Whitaker Cone
b. 1892
11
Ulysses Erwin Maner Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.14.3]
b. 9 Apr 1890 d. 31 Jul 1979
11
James Longstreet Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.14.4]
b. 29 Aug 1891 d. 24 May 1980
+
Annie Conrad
b. 1895
11
Josephine King Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.14.5]
b. 13 May 1893 d. 5 May 1980
+
Henry Burritt Jennings
b. 1 Aug 1883 d. Jul 1927
11
Mary Eve Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.14.6]
b. 28 Nov 1895 d. 14 Dec 1918
11
Josiah Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.14.7]
b. 16 Sep 1898 d. 28 Dec 1965
11
William Augustus Longstreet Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.14.8]
b. 12 Feb 1900 d. 1 Dec 1994
11
Marion Erwin Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.14.9]
b. 12 Jan 1902 d. Jun 1985
11
Alan Bowen Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.14.10]
b. 22 Sep 1903 d. 13 Aug 1990
10
Mary Bones Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.15]
b. 29 Mar 1865 d. 22 Jun 1954
10
Emma Josephine Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.16]
b. 23 Feb 1867 d. 25 Oct 1957
Butler King Couper
b. Abt 1851 d. 20 Oct 1913
11
Constance Maxwell Couper
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.16.1]
b. 1897 d. 1985
11
Butler King Couper
[1.1.1.1.2.1.1.1.2.16.2]
b. 1906 d. 1957
8
Lydia Sibley
[1.1.1.1.2.1.1.2]
b. 2 Apr 1769 d. 27 Nov 1822
Henry Staples Benson
b. 8 Aug 1770 d. 29 Jul 1821
9
Abigail Benson
[1.1.1.1.2.1.1.2.1]
b. 31 Mar 1795 d. 10 Nov 1821
Asa Legg
b. 7 May 1792 d. 15 Nov 1836
10
Charlotte Legg
[1.1.1.1.2.1.1.2.1.1]
b. 2 May 1818 d. 30 Oct 1900
George Perrier Stawitts
b. 3 Jul 1820 d. 1897
11
Jacob Stawitts
[1.1.1.1.2.1.1.2.1.1.1]
b. Abt 1844
11
Cornelius Stanton Stawitts
[1.1.1.1.2.1.1.2.1.1.2]
b. 17 Feb 1846 d. 2 May 1914
Maria Putman
b. Abt 1845
12
Laura Stawitts
[1.1.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1]
b. 1881
11
Herbert Stawitts
[1.1.1.1.2.1.1.2.1.1.3]
b. Abt 1848 d. Abt 1852
11
Emma Stawitts
[1.1.1.1.2.1.1.2.1.1.4]
b. Abt 1850
10
Lyman Legg
[1.1.1.1.2.1.1.2.1.2]
b. 3 Sep 1822 d. 1 Sep 1904
Hannah Thayer
b. 11 Feb 1820
11
Enoch J Legg
[1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.1]
b. 25 Sep 1846
11
Enda Isadore Legg
[1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.2]
b. 25 Sep 1846 d. 1 Sep 1914
+
Warren Henry Holt
b. 7 Dec 1847
11
Sarah Thayer Legg
[1.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3]
b. 20 Oct 1850
9
Harriet Benson
[1.1.1.1.2.1.1.2.2]
b. 14 Sep 1796 d. 22 Aug 1852
9
Mellen Benson
[1.1.1.1.2.1.1.2.3]
b. 14 Jan 1798
Eliza W Farnum
b. 25 Sep 1802 d. 14 Sep 1839
10
Henry Staples Benson
[1.1.1.1.2.1.1.2.3.1]
b. 17 May 1829
10
Almira Farnum Benson
[1.1.1.1.2.1.1.2.3.2]
b. 6 Aug 1830 d. 25 Dec 1835
10
James Haskins Benson
[1.1.1.1.2.1.1.2.3.3]
b. 16 Oct 1833
10
George Everett Benson
[1.1.1.1.2.1.1.2.3.4]
b. 14 Aug 1837
+
Mary Windsor Peck
b. 21 May 1798
9
Hannah Adaline Benson
[1.1.1.1.2.1.1.2.4]
b. 12 Aug 1802 d. 19 Jun 1822
9
Rufus Benson
[1.1.1.1.2.1.1.2.5]
b. 24 Jan 1804 d. 23 Aug 1805
9
Chloe Ann Benson
[1.1.1.1.2.1.1.2.6]
b. 23 Aug 1806
+
Dan Hill
b. 29 Nov 1796
9
Susan Augusta Benson
[1.1.1.1.2.1.1.2.7]
b. 9 Oct 1809 d. 25 Jul 1831
Preserved Smith Thayer
b. 9 May 1808
10
Susan Benson Thayer
[1.1.1.1.2.1.1.2.7.1]
b. 28 Jun 1831 d. 14 Aug 1909
+
Daniel Wheelock Aldrich
b. 28 Aug 1822 d. 23 May 1891
9
Rufus Aldrich Benson
[1.1.1.1.2.1.1.2.8]
b. 9 Oct 1809
+
Sarah E Buell
9
Stephen Sibley Benson
[1.1.1.1.2.1.1.2.9]
b. 9 Jan 1810 d. 20 Nov 1869
Elizabeth Richardson Scott
b. 8 Jan 1835 d. 20 Feb 1911
10
Jessie Harriet Benson
[1.1.1.1.2.1.1.2.9.1]
b. 7 Jun 1860
+
John Robert Forbes Love
b. 22 Jun 1856
10
Fred Mellen Benson
[1.1.1.1.2.1.1.2.9.2]
b. 10 Nov 1862 d. 9 May 1864
10
Susie Adeline Benson
[1.1.1.1.2.1.1.2.9.3]
b. 6 Aug 1865
7
Ebenezer Sibley
[1.1.1.1.2.1.2]
b. 9 Oct 1745
Mary Chase
b. 15 Mar 1741 d. 1784
8
Sarah Sibley
[1.1.1.1.2.1.2.1]
b. 19 Dec 1772
8
Lucy Sibley
[1.1.1.1.2.1.2.2]
b. 2 Mar 1775
+
Forbes Bond
b. Abt 1773
8
Eunice Sibley
[1.1.1.1.2.1.2.3]
b. 1 Mar 1777
8
Elias Sibley
[1.1.1.1.2.1.2.4]
b. 8 Aug 1779 d. 1856
Ruth Chase
b. 31 Jan 1780 d. Abt 1858
9
Alonzo Sibley
[1.1.1.1.2.1.2.4.1]
b. 14 Jul 1810 d. 16 Mar 1896
Mary Heath
b. 10 Sep 1813 d. 1836
10
Son Sibley
[1.1.1.1.2.1.2.4.1.1]
b. 20 Oct 1836 d. 5 Dec 1836
Sarah Ann Heath
b. 10 Apr 1812 d. 1873
10
Daughter Sibley
[1.1.1.1.2.1.2.4.1.2]
b. 1838 d. 7 Jul 1838
10
Mary Jane Sibley
[1.1.1.1.2.1.2.4.1.3]
b. 17 Nov 1840 d. 15 Feb 1922
James Pratt
b. May 1835
11
Melville S Pratt
[1.1.1.1.2.1.2.4.1.3.1]
b. 5 May 1868 d. 7 Mar 1947
+
Ellen Price
11
Maude Ethlyn Pratt
[1.1.1.1.2.1.2.4.1.3.2]
b. 17 Jun 1871 d. 6 Nov 1897
11
Judson Edmond Pratt
[1.1.1.1.2.1.2.4.1.3.3]
b. 12 Mar 1885 d. Apr 1972
+
Nina Beatrice Wells
11
Emma G Pratt
[1.1.1.1.2.1.2.4.1.3.4]
b. 23 Jun 1888
10
Harriet A Sibley
[1.1.1.1.2.1.2.4.1.4]
b. 25 Nov 1842 d. 6 Jul 1886
James Bryant Drew
b. 11 Nov 1838 d. 8 Apr 1903
11
Ray Sibley Drew
[1.1.1.1.2.1.2.4.1.4.1]
b. 17 Apr 1870 d. 14 Feb 1949
Sophronia Elmira Severance
b. 13 Nov 1872 d. 23 Dec 1951
12
Mabelle Harriett Drew
[1.1.1.1.2.1.2.4.1.4.1.1]
b. 22 Sep 1895 d. 4 Sep 1973
12
Marian Adalade Drew
[1.1.1.1.2.1.2.4.1.4.1.2]
b. 11 Apr 1897 d. 10 Jul 1973
12
Marietta Janette Drew
[1.1.1.1.2.1.2.4.1.4.1.3]
b. 2 Jun 1898 d. 28 Feb 1940
12
Mildred Irene Drew
[1.1.1.1.2.1.2.4.1.4.1.4]
b. 9 Sep 1901 d. 8 Dec 1995 [
=>
]
10
Watson A Sibley
[1.1.1.1.2.1.2.4.1.5]
b. 1844 d. 24 Apr 1924
Margaret H. Hubbell
b. Jul 1849
11
Guy Hubbell Sibley
[1.1.1.1.2.1.2.4.1.5.1]
b. 8 Dec 1872 d. 19 Mar 1936
11
Caroline A Sibley
[1.1.1.1.2.1.2.4.1.5.2]
b. 3 Nov 1874 d. Mar 1976
11
May Viola Sibley
[1.1.1.1.2.1.2.4.1.5.3]
b. 30 Apr 1876
11
Cora I Sibley
[1.1.1.1.2.1.2.4.1.5.4]
b. 11 Jul 1880
10
Judson L Sibley
[1.1.1.1.2.1.2.4.1.6]
b. Oct 1846
Lucia Emma Banks
b. Jun 1851
11
Gertrude R Sibley
[1.1.1.1.2.1.2.4.1.6.1]
b. 6 Nov 1876
+
James Wilson Clapp
+
Adeline Colby
b. 10 Jun 1818 d. 18 Mar 1896
8
Ebenezer Sibley, Jr
[1.1.1.1.2.1.2.5]
b. 18 Jan 1782 d. 15 Mar 1827
Polly B Whipple
b. 16 Jun 1791
9
Lorinda Sibley
[1.1.1.1.2.1.2.5.1]
b. 6 Jul 1810
+
Charles Arnold
9
Maria Sibley
[1.1.1.1.2.1.2.5.2]
b. 23 Jul 1812
Whitcomb Gray
b. Abt 1804 d. 10 Jan 1888
10
Delia Maria Gray
[1.1.1.1.2.1.2.5.2.1]
b. 1834
+
James Carpenter
b. 1832
10
Mary Ann Grey
[1.1.1.1.2.1.2.5.2.2]
c. 20 Mar 1836
+
Moses H. Rumery
b. 1831
9
Polly Sibley
[1.1.1.1.2.1.2.5.3]
b. 11 Sep 1814
9
Mary Sibley
[1.1.1.1.2.1.2.5.4]
b. 8 Mar 1817 d. 17 Jun 1903
Benjamin Cragin
b. 6 Mar 1814 d. 20 Jan 1896
10
Mary Emma Cragin
[1.1.1.1.2.1.2.5.4.1]
b. 12 Dec 1839 d. 25 Aug 1924
Joshua Vose
b. 6 Jul 1838 d. 10 Apr 1918
11
Hattie M Vose
[1.1.1.1.2.1.2.5.4.1.1]
b. 20 Mar 1869 d. Aft 1930
Elmer Ellsworth Carpenter
b. Oct 1863 d. 17 Dec 1936
12
Marjorie Vose Carpenter
[1.1.1.1.2.1.2.5.4.1.1.1]
b. 6 Jan 1897
11
Mary Louise Vose
[1.1.1.1.2.1.2.5.4.1.2]
b. 24 Sep 1875
10
Maria A Cragin
[1.1.1.1.2.1.2.5.4.2]
b. 27 Dec 1844
9
Loren Elba Sibley
[1.1.1.1.2.1.2.5.5]
b. 3 May 1821
8
Zadock Sibley
[1.1.1.1.2.1.2.6]
b. 12 Oct 1785
8
Mary Sibley
[1.1.1.1.2.1.2.7]
b. 1 Feb 1789 d. 24 Apr 1844
+
Amos Peirce
b. Abt 1786 d. 22 Dec 1848
7
Abigail Sibley
[1.1.1.1.2.1.3]
b. 22 Jan 1747
7
Peter Sibley
[1.1.1.1.2.1.4]
b. 16 Sep 1749
7
Mary Sibley
[1.1.1.1.2.1.5]
b. 20 Jan 1751
6
Stephen Sibley
[1.1.1.1.2.2]
b. 1 Oct 1720
Mrs Sibley
b. Abt 1725
7
Elias Sibley
[1.1.1.1.2.2.1]
b. Abt 1745
6
Bethiah Sibley
[1.1.1.1.2.3]
b. 2 Oct 1724 d. 1 Jul 1756
Samuel Trask
b. 17 Dec 1721 d. 7 Mar 1790
7
John Trask
[1.1.1.1.2.3.1]
b. 29 Sep 1744
7
Hannah Trask
[1.1.1.1.2.3.2]
b. 10 Nov 1746
7
Sarah Trask
[1.1.1.1.2.3.3]
b. 10 Sep 1753 d. 22 Aug 1830
Major Simon Tenney
b. 13 Sep 1746 d. 14 Aug 1838
8
Major Daniel Tenney
[1.1.1.1.2.3.3.1]
b. 23 Nov 1773
Betsey Waters
b. 12 Jul 1776 d. 16 Aug 1851
9
Sarah Tenney
[1.1.1.1.2.3.3.1.1]
b. 6 Oct 1797 d. 13 Apr 1880
Edmond John Mills
b. 17 Aug 1791 d. 11 Sep 1889
10
Wiliam Edmund Mills
[1.1.1.1.2.3.3.1.1.1]
b. 2 Nov 1825 d. 18 Dec 1914
Electa Jane Dusenbury
b. 18 Apr 1828 d. 6 Oct 1908
11
Frank Henry Mills
[1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.1]
b. 17 Aug 1853 d. 1903
Mary A Gorton
b. Mar 1856 d. 1903
12
Maud Antha Mills
[1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.1.1]
b. 28 Dec 1874
12
Clarence W Mills
[1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.1.2]
b. 22 Feb 1877 [
=>
]
12
Frank Edmund Mills
[1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.1.3]
b. 19 Feb 1879
12
Lewis Henry Mills
[1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.1.4]
b. 2 Nov 1880
11
Frances Harriet Mills
[1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.2]
b. 17 Aug 1853 d. 1903
+
James P Coates
b. Oct 1852 d. 1903
11
William Edmond Mills
[1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3]
b. 4 Jul 1855
Alice
b. Abt 1860
12
Harry E Mills
[1.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3.1]
b. 15 Nov 1879
10
Nancy Tenney Mills
[1.1.1.1.2.3.3.1.1.2]
b. 15 Mar 1828 d. 12 Jun 1880
Leander C Taylor
b. 1826 d. 12 Jan 1902
11
Elizabeth Jane Taylor
[1.1.1.1.2.3.3.1.1.2.1]
b. Abt 1857 d. 23 Nov 1885
10
Samuel John Mills
[1.1.1.1.2.3.3.1.1.3]
b. 17 Nov 1830 d. 23 Jan 1838
10
Son Mills
[1.1.1.1.2.3.3.1.1.4]
b. 1 Mar 1835 d. 31 Mar 1835
10
Franklin Lewis Mills
[1.1.1.1.2.3.3.1.1.5]
b. 24 Oct 1836 d. 14 Feb 1918
+
Susannah E Kraft
b. Sep 1846 d. 30 Mar 1876
Caroline Morse
b. 23 Apr 1856 d. 1900
11
Sarah Jane Mills
[1.1.1.1.2.3.3.1.1.5.1]
b. 4 Jul 1881 d. 18 Jan 1889
11
Grace Evelyn Mills
[1.1.1.1.2.3.3.1.1.5.2]
b. 7 Nov 1891 d. Aft 1900
10
Sarah Maria Mills
[1.1.1.1.2.3.3.1.1.6]
b. 18 Aug 1841
9
Sally Tenney
[1.1.1.1.2.3.3.1.2]
b. 6 Oct 1797
9
Simon Tenney
[1.1.1.1.2.3.3.1.3]
b. 3 Dec 1799 d. 11 Jun 1856
Nancy Putnam
b. 17 Feb 1800
10
David Tenney
[1.1.1.1.2.3.3.1.3.1]
b. Abt 1830
10
Daniel Tenney
[1.1.1.1.2.3.3.1.3.2]
b. 29 Feb 1832 d. 6 Dec 1844
10
George Tenney
[1.1.1.1.2.3.3.1.3.3]
b. 30 Jan 1837 d. 29 Oct 1839
9
John Waters Tenney
[1.1.1.1.2.3.3.1.4]
b. 25 Jul 1802 d. 29 Apr 1849
Eliza Tileston Fisher
b. 13 May 1803 d. 21 Aug 1847
10
Edward Waters Tenney
[1.1.1.1.2.3.3.1.4.1]
b. Aug 1830
Lucene Ida Haines
b. 8 Oct 1859
11
Lena L Tenny
[1.1.1.1.2.3.3.1.4.1.1]
b. Feb 1879 d. 1942
+
Martin Christ Mannion
b. 8 Nov 1878 d. 1934
11
Charles William Tenney
[1.1.1.1.2.3.3.1.4.1.2]
b. 3 Jan 1882
9
Linus Tenney
[1.1.1.1.2.3.3.1.5]
b. 5 Dec 1804
Sally Elwell
b. 2 Dec 1806
10
Charles Linus Tenney
[1.1.1.1.2.3.3.1.5.1]
b. 12 Jan 1829
Catherine Fisk Robbins
b. 1 Nov 1837 d. 8 Feb 1902
11
Edith Frances Tenney
[1.1.1.1.2.3.3.1.5.1.1]
b. 4 Jul 1860 d. 28 Jan 1872
11
Eleanore Amelia Tenney
[1.1.1.1.2.3.3.1.5.1.2]
b. 15 Aug 1862 d. 15 Jan 1865
11
Eva Nena Tenney
[1.1.1.1.2.3.3.1.5.1.3]
b. 8 Apr 1867 d. 12 Nov 1943
+
Herbert Edwin Derby
d. 2 Aug 1934
11
Lucius E Tenney
[1.1.1.1.2.3.3.1.5.1.4]
b. 22 Jul 1874 d. 1 Jul 1905
11
Rhoda Hannah Tenney
[1.1.1.1.2.3.3.1.5.1.5]
b. 13 Sep 1876
10
George Franklin Tenney
[1.1.1.1.2.3.3.1.5.2]
b. 7 Sep 1831 d. 24 Nov 1831
10
James Henry Tenney
[1.1.1.1.2.3.3.1.5.3]
b. 10 Jun 1838
Arabella Adeline Prichard
b. 11 Oct 1842 d. 22 Mar 1907
11
James Edgar Tenney
[1.1.1.1.2.3.3.1.5.3.1]
b. 2 Apr 1863 d. 6 Jan 1890
11
Florence Mabelle Tenney
[1.1.1.1.2.3.3.1.5.3.2]
b. 10 May 1869 d. 15 Mar 1871
11
Grace Elwell Tenney
[1.1.1.1.2.3.3.1.5.3.3]
b. 10 May 1873
+
Charles Edward Harrison
b. 1872
11
Blanche Mack Tenney
[1.1.1.1.2.3.3.1.5.3.4]
b. 27 Sep 1876
+
Frank Morgan Boutelle
b. 1875
11
Ethel Prichard Tenney
[1.1.1.1.2.3.3.1.5.3.5]
b. 18 Dec 1879 d. 6 Jan 1884
9
Nancy Tenney
[1.1.1.1.2.3.3.1.6]
b. 21 Jan 1808 d. 29 May 1822
9
Danial Austin Tenney
[1.1.1.1.2.3.3.1.7]
b. 29 Aug 1811 d. 7 Feb 1871
Marietta Margaret Marcy
b. 11 Jun 1811
10
Daniel Austin Tenney
[1.1.1.1.2.3.3.1.7.1]
b. 15 Oct 1835
Maria Louisa Newton
b. 20 Jul 1843
11
Mary Effie Tenney
[1.1.1.1.2.3.3.1.7.1.1]
b. 12 Jul 1868
11
Ada Mabel Tenney
[1.1.1.1.2.3.3.1.7.1.2]
b. 25 Jan 1870
10
Joseph Starks Tenney
[1.1.1.1.2.3.3.1.7.2]
b. 24 Feb 1838
Emily M Paine
b. Abt 1842
11
George Arthur Tenney
[1.1.1.1.2.3.3.1.7.2.1]
b. 8 Oct 1858
10
George Laban Tenney
[1.1.1.1.2.3.3.1.7.3]
b. 25 Jul 1840
10
Frederick Prescott Tenney
[1.1.1.1.2.3.3.1.7.4]
b. 6 Jul 1845
10
Frank Herbert Tenney
[1.1.1.1.2.3.3.1.7.5]
b. 16 Jan 1849
Ellen Arnold Searles
b. 6 Mar 1847 d. 7 Oct 1904
11
Fannie Augusta Tenney
[1.1.1.1.2.3.3.1.7.5.1]
b. 7 Aug 1878
9
Benjamin Franklin Tenney
[1.1.1.1.2.3.3.1.8]
b. 28 Oct 1813 d. 26 Oct 1900
Frances Bridges Veagie
b. 7 Mar 1819 d. 24 Oct 1858
10
Joseph Franklin Tenney
[1.1.1.1.2.3.3.1.8.1]
b. 12 Nov 1838 d. 1878
Mary Bowman Viles
b. 17 Feb 1831
10
Frank Tenney
[1.1.1.1.2.3.3.1.8.2]
b. 4 Feb 1861
10
Arthur Tenney
[1.1.1.1.2.3.3.1.8.3]
b. 1 Jun 1863 d. 16 Jun 1866
10
Maud Tenney
[1.1.1.1.2.3.3.1.8.4]
b. 13 May 1875 d. 30 Jun 1896
Frank Foster Sherburne
11
Ruth Sherburne
[1.1.1.1.2.3.3.1.8.4.1]
b. 18 Jun 1893
11
Elizabeth Sherburne
[1.1.1.1.2.3.3.1.8.4.2]
b. 25 Jul 1894
11
Tenny Sherburne
[1.1.1.1.2.3.3.1.8.4.3]
b. 24 Jun 1899
7
Samuel Trask, Jr
[1.1.1.1.2.3.4]
b. 26 Aug 1749
Ruth Tenney
b. 16 Mar 1753 d. 27 Apr 1789
8
Samuel Trask, III
[1.1.1.1.2.3.4.1]
b. 10 Dec 1773
8
Simon Trask
[1.1.1.1.2.3.4.2]
b. 13 Jan 1775
8
Hannah Trask
[1.1.1.1.2.3.4.3]
b. 4 Feb 1777
8
Stephen Trask
[1.1.1.1.2.3.4.4]
b. 18 Feb 1779
8
Salley Trask
[1.1.1.1.2.3.4.5]
b. 17 Jan 1784 d. 5 Feb 1819
Elijah Holman
9
Jonathan Holman
[1.1.1.1.2.3.4.5.1]
b. 21 Jun 1813 d. 24 Oct 1816
9
Sarah Trask Holman
[1.1.1.1.2.3.4.5.2]
b. 16 May 1816 d. 8 May 1847
Sherman Hale
b. Abt 1812
10
Anna Hale
[1.1.1.1.2.3.4.5.2.1]
b. Abt 1838
10
Ann Hale
[1.1.1.1.2.3.4.5.2.2]
b. 1840
10
Emily Hale
[1.1.1.1.2.3.4.5.2.3]
b. Jul 1841 d. 2 Nov 1906
10
Anna H Hale
[1.1.1.1.2.3.4.5.2.4]
b. Feb 1843 d. 5 Jan 1929
10
Sarah Frank Hale
[1.1.1.1.2.3.4.5.2.5]
b. 16 Dec 1844 d. 30 Oct 1933
10
Charles T H Hale
[1.1.1.1.2.3.4.5.2.6]
b. 1846
9
Son Holman
[1.1.1.1.2.3.4.5.3]
b. Abt 1819 d. 23 Feb 1826
Allice Perry
b. Abt 1759
8
Talmon Trask
[1.1.1.1.2.3.4.6]
c. 6 Oct 1799
8
Danforth Trask
[1.1.1.1.2.3.4.7]
c. 27 Nov 1801
8
Dexter Trask
[1.1.1.1.2.3.4.8]
c. 11 Aug 1807
8
Edwin Trask
[1.1.1.1.2.3.4.9]
c. 29 Sep 1809
8
Angelina Trask
[1.1.1.1.2.3.4.10]
c. 26 Oct 1811
7
Anne Trask
[1.1.1.1.2.3.5]
b. 9 Oct 1757
6
Timothy Sibley
[1.1.1.1.2.4]
b. 2 Nov 1727 d. 6 Dec 1818
Ann Waite
b. 14 Oct 1733 d. 12 Mar 1791
7
John Sibley
[1.1.1.1.2.4.1]
b. 19 May 1757 d. 8 Apr 1837
Betsey Hopkins
b. Abt 1754 d. 1790
8
George Champlin Sibley
[1.1.1.1.2.4.1.1]
b. 1 Apr 1782 d. 31 Jan 1863
+
Mary Smith Easton
b. 24 Jan 1800 d. 20 Jun 1878
7
Timothy Sibley
[1.1.1.1.2.4.2]
b. 19 Jun 1754 d. 26 Aug 1829
Mary
b. Abt 1756
8
Timothy Willard Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.1]
b. 11 Sep 1779 d. 11 Mar 1820
Elizabeth Comins
d. 2 Mar 1820
9
William C Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.1.1]
b. 20 Jun 1812
9
Sarah Elizabeth Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.1.2]
b. 2 Jan 1814
9
Mary Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.1.3]
b. 26 Sep 1815
9
Amanda M Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.1.4]
b. 25 Jun 1817
9
Nancy W Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.1.5]
b. 10 Jul 1819
Francis S Putney
b. 20 Oct 1818
10
William Frank Putney
[1.1.1.1.2.4.2.1.5.1]
b. 23 Sep 1844 d. 11 Feb 1847
10
Frank Edward Putney
[1.1.1.1.2.4.2.1.5.2]
b. 12 Apr 1847 d. Dec 1849
10
William Sibley Putney
[1.1.1.1.2.4.2.1.5.3]
b. 24 Mar 1849 d. 16 Jan 1933
+
Lavina Jane Call
b. 14 Aug 1852
10
Clara A Putney
[1.1.1.1.2.4.2.1.5.4]
b. 28 Sep 1850
10
Mary Ann Putney
[1.1.1.1.2.4.2.1.5.5]
b. 25 Dec 1852 d. 13 May 1881
Sheldon M Scribner
b. 22 Sep 1848
11
Howard S Scribner
[1.1.1.1.2.4.2.1.5.5.1]
b. 29 Jul 1876
11
Harlan W Scribner
[1.1.1.1.2.4.2.1.5.5.2]
b. 6 Mar 1878
11
Orrin F Scribner
[1.1.1.1.2.4.2.1.5.5.3]
b. 23 Sep 1879 d. 10 Jul 1880
10
Josephine E Putney
[1.1.1.1.2.4.2.1.5.6]
b. 16 Dec 1854 d. 26 Dec 1857
10
Orrin F Putney
[1.1.1.1.2.4.2.1.5.7]
b. 20 Dec 1856 d. 20 Mar 1881
10
Luther C Putney
[1.1.1.1.2.4.2.1.5.8]
b. 26 Jul 1859 d. 1920
Anna P Wadleigh
b. 11 Oct 1868 d. 6 Aug 1894
11
Winnifred Maude Putney
[1.1.1.1.2.4.2.1.5.8.1]
b. 8 Oct 1893
+
Samuel V Phillips
b. 1890
10
Fred Willard Putney
[1.1.1.1.2.4.2.1.5.9]
b. 21 Jan 1866 d. 26 Dec 1930
Evelyn Angusta Breed
b. 26 Mar 1869 d. 19 May 1932
11
Luther Roy Putney
[1.1.1.1.2.4.2.1.5.9.1]
b. 10 Jun 1890
+
Annie C. Fennels
b. 22 Feb 1892
9
Almira S Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.1.6]
8
Mary Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.2]
b. 5 Dec 1780
+
Amariah Scarboro
8
Anne Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.3]
b. 15 Jan 1782
8
Cyrus Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.4]
b. 6 Jan 1784
Eliza Ann Humphries
b. 9 Sep 1809 d. 4 Oct 1884
9
Artemas Origin Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.4.1]
b. 9 Mar 1829
Eloise Soria
10
Robert A Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.4.1.1]
b. 25 Nov 1855 d. 18 Jul 1902
10
Artemise Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.4.1.2]
b. 1861
10
Eugene Walter Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.4.1.3]
b. 25 Mar 1865 d. 23 Apr 1945
Florence Cleora D'Olive
11
Florence Eloise Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.4.1.3.1]
b. 9 Aug 1890 d. 14 Jun 1983
+
Daniel Hancock Burcky
b. 19 Dec 1884 d. 17 Oct 1966
11
Eugene Soria Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.4.1.3.2]
b. 9 Jul 1892 d. 9 Sep 1960
11
Cyrus Rufus Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.4.1.3.3]
b. 18 Oct 1896 d. 11 Sep 1939
11
William Fonde Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.4.1.3.4]
b. 1904 d. 19 Nov 1937
Winifred Palmer Zieman
b. 15 Sep 1903 d. 28 Aug 1990
12
Living
[1.1.1.1.2.4.2.4.1.3.4.1]
[
=>
]
12
Living
[1.1.1.1.2.4.2.4.1.3.4.2]
[
=>
]
11
Vernon Lynnwood Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.4.1.3.5]
b. 23 Sep 1907 d. 25 Jul 1974
10
Cyrus Artemas Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.4.1.4]
b. 25 Aug 1866 d. 25 Aug 1949
Elizabeth O'Conner
b. 2 Apr 1883 d. 19 Nov 1970
11
Cyrus Artemus Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.4.1.4.1]
b. 1904
10
Hattie S Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.4.1.5]
b. 1870
10
Annie Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.4.1.6]
b. 1872
10
William Soria Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.4.1.7]
b. 12 Sep 1874 d. 12 Feb 1968
9
Salome Jane Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.4.2]
b. 19 Dec 1829 d. 12 Apr 1835
9
Artemesia Ann Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.4.3]
b. 31 Jul 1830 d. 1 Sep 1903
Robert Brown Searing
b. 15 May 1829 d. 2 May 1890
10
Robert Brian Searing
[1.1.1.1.2.4.2.4.3.1]
b. 1859 d. 1878
10
Harry Pond Searing
[1.1.1.1.2.4.2.4.3.2]
b. 1863 d. 20 Dec 1873
10
Cyrus Sibley Searing
[1.1.1.1.2.4.2.4.3.3]
10
Florence Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.4.3.4]
10
Theodore Searing
[1.1.1.1.2.4.2.4.3.5]
9
Willard Franklin Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.4.4]
b. 18 Apr 1835
9
Cyrus Blue Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.4.5]
b. 18 Apr 1837
9
Helena Jane Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.4.6]
b. 27 May 1839
9
Henrietta Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.4.7]
b. 1842 d. 6 Feb 1892
9
Walter Howard Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.4.8]
9
Augustus Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.4.9]
8
Artemas Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.5]
b. 21 Apr 1786
8
Salome Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.6]
b. 13 Apr 1788 d. Aft 1880
Elijah Jewett
b. 8 Feb 1782 d. 1879
9
John F Jewett
[1.1.1.1.2.4.2.6.1]
b. 1817
+
Elizabeth How
b. Abt 1819
9
Origin Sibley Jewett
[1.1.1.1.2.4.2.6.2]
b. 20 Apr 1820 d. 19 Sep 1863
Clara Lee James
b. 25 Oct 1832 d. 1912
10
Origin Sibley Jewett
[1.1.1.1.2.4.2.6.2.1]
b. 1860 d. 1908
Virginia Flinn
b. 26 Jul 1871 d. 17 Apr 1942
11
Son Jewett
[1.1.1.1.2.4.2.6.2.1.1]
b. 12 Dec 1905 d. 12 Dec 1905
9
Mary Elizabeth Jewett
[1.1.1.1.2.4.2.6.3]
b. Abt 1821 d. 1901
Armistead M Elgin
b. 1819
10
Isabella Elgin
[1.1.1.1.2.4.2.6.3.1]
b. 20 May 1857 d. 30 May 1924
Cornelius E Thames
b. 1859
11
Armistead Elgin Thames
[1.1.1.1.2.4.2.6.3.1.1]
b. Abt 1884 d. 22 Jan 1964
11
Cornelius E Thames, Jr
[1.1.1.1.2.4.2.6.3.1.2]
b. Abt 1886 d. Aft 1940
11
Eugene Thames
[1.1.1.1.2.4.2.6.3.1.3]
b. Abt 1889 d. 8 Jun 1942
Kathryn McKee
b. Abt 1896 d. Aft 1940
12
Living
[1.1.1.1.2.4.2.6.3.1.3.1]
10
Willie A Elgin
[1.1.1.1.2.4.2.6.3.2]
b. 18 Jan 1860 d. 12 Apr 1875
10
Clara J Elgin
[1.1.1.1.2.4.2.6.3.3]
b. Abt 1863 d. 25 Apr 1959
+
John H Fitzpatrick
b. Abt 1860
10
Elizabeth May Elgin
[1.1.1.1.2.4.2.6.3.4]
b. 1867 d. 24 Jan 1936
+
Edward Gray Caufman
b. 17 Sep 1834 d. 5 Mar 1907
8
Benijamin Franklin Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.7]
b. 19 Jul 1790
8
Origen Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.8]
b. 1792 d. 1870
Elizabeth Barlow
b. 8 May 1815 d. 2 Jul 1875
9
Josephine Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.8.1]
b. 2 Jul 1835 d. 3 Mar 1873
George W Barnaby
d. 1859
10
Bessie Barnaby
[1.1.1.1.2.4.2.8.1.1]
b. 14 Jan 1857
+
Martin Kent Northam
10
George Adam Barnaby
[1.1.1.1.2.4.2.8.1.2]
b. 14 Jan 1857 d. 1897
William Motley Stevens
d. 1870
10
Lloyd Motley Stevens
[1.1.1.1.2.4.2.8.1.3]
b. 13 Jan 1869 d. 13 Jun 1955
9
Salome Elizabeth Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.8.2]
b. 19 Aug 1837 d. 1 Nov 1893
Nathaniel Ragan King
b. 18 Jun 1831 d. 19 Nov 1863
10
Marietta King
[1.1.1.1.2.4.2.8.2.1]
b. 8 Sep 1858
William M King
11
Harvey King
[1.1.1.1.2.4.2.8.2.1.1]
b. 16 Jul 1891
10
Sibley Paul King
[1.1.1.1.2.4.2.8.2.2]
b. 5 Jun 1860
10
Idyl King
[1.1.1.1.2.4.2.8.2.3]
b. 23 Feb 1862
William Edwin Gorsby
11
Paul Clinton Gorsby
[1.1.1.1.2.4.2.8.2.3.1]
10
Nathalie Ragan King
[1.1.1.1.2.4.2.8.2.4]
b. 6 May 1863
Charles Friend Warriner
b. 28 Jan 1855
11
Olga G Warriner
[1.1.1.1.2.4.2.8.2.4.1]
b. 14 Jan 1889
+
Anderson S. Barnes
11
Nathalie Warriner
[1.1.1.1.2.4.2.8.2.4.2]
b. 17 Jan 1890
11
Mabel Warriner
[1.1.1.1.2.4.2.8.2.4.3]
b. 6 Mar 1891
11
Laura Salome Warriner
[1.1.1.1.2.4.2.8.2.4.4]
b. 1893
9
Origen Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.8.3]
b. 6 Feb 1840
Harriet A Brainerd
b. 1 Feb 1845
10
James Brainard Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.8.3.1]
b. 15 May 1869
+
Adele Estelle Ward
10
Origen Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.8.3.2]
b. 30 Jun 1872
10
Orlean Emma Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.8.3.3]
b. 30 Jun 1872 d. 27 Oct 1872
10
Will Owen Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.8.3.4]
b. 1 May 1880 d. 13 Aug 1880
9
Laura Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.8.4]
b. 1842
William G McNeill
10
Mary Elizabeth McNeill
[1.1.1.1.2.4.2.8.4.1]
b. 8 Mar 1865
Ludolph Chester
11
Alan Chester
[1.1.1.1.2.4.2.8.4.1.1]
10
William Stoddard McNeill
[1.1.1.1.2.4.2.8.4.2]
b. 6 Dec 1866 d. 14 Apr 1868
10
Laurence Harvey McNeill
[1.1.1.1.2.4.2.8.4.3]
b. 10 Aug 1869
10
Fanny Ethel McNeill
[1.1.1.1.2.4.2.8.4.4]
b. 21 May 1871
10
Daniel McNeill
[1.1.1.1.2.4.2.8.4.5]
b. 22 Sep 1872
10
Lila Douglas McNeill
[1.1.1.1.2.4.2.8.4.6]
b. 10 Apr 1877 d. 1954
9
Franklin Edward Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.8.5]
b. 1844
Ida K Sterne
10
Helen May Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.8.5.1]
b. 1879 d. 1880
10
Frank Eillott Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.8.5.2]
b. 1881 d. 1943
10
Ida Valerie Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.8.5.3]
b. 1883 d. 1979
10
Julian Dannis Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.8.5.4]
b. 1885 d. 1964
10
Rowland Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.8.5.5]
b. 1890 d. 1901
9
Helen Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.8.6]
b. 15 Dec 1846 d. 1940
Audubon Gullette
10
Laura Helen Gullette
[1.1.1.1.2.4.2.8.6.1]
b. 30 Oct 1867
Samuel Barlow
b. Abt 1867
11
Nellie Barlow
[1.1.1.1.2.4.2.8.6.1.1]
b. 1888
10
Elizabeth Gullette
[1.1.1.1.2.4.2.8.6.2]
b. 1869
+
Albert Putnam
10
Eugenia Gullette
[1.1.1.1.2.4.2.8.6.3]
b. 9 Mar 1874
+
Samuel Cad Wallader Dodge
9
Charles Sweet Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.8.7]
b. 25 Jan 1849
Edna G D'Olive
b. 1872
10
Edna Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.8.7.1]
b. Dec 1890 d. 1987
9
Eugene Wilson Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.8.8]
b. 16 Sep 1851 d. 4 Mar 1911
Minnie M Sterne
10
Edward Austin Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.8.8.1]
d. 1960
10
Elizabeth Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.8.8.2]
d. 1896
10
Laurence Sterne Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.8.8.3]
d. 1901
9
Guy Clarence Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.8.9]
b. 1855
Susie Witherspoon Shipman
b. 29 Apr 1858 d. 27 Mar 1934
10
Guy Clarence Shipley, Jr
[1.1.1.1.2.4.2.8.9.1]
b. 28 Jan 1883 d. 21 Feb 1912
9
Julia Eve Sibley
[1.1.1.1.2.4.2.8.10]
b. 16 Jan 1856
Edward L Barnes
b. 23 Jan 1850
10
Anderson Barnes
[1.1.1.1.2.4.2.8.10.1]
b. 28 Oct 1877
+
Olga Warines
b. 1889
10
Origen Sibley Barnes
[1.1.1.1.2.4.2.8.10.2]
b. 2 Sep 1879 d. 1884
10
Edward L Barnes
[1.1.1.1.2.4.2.8.10.3]
+
Annie
10
Pendleton Barnes
[1.1.1.1.2.4.2.8.10.4]
10
Sager Barnes
[1.1.1.1.2.4.2.8.10.5]
7
Joshua Sibley
[1.1.1.1.2.4.3]
b. 16 Nov 1755 d. 29 Sep 1774
7
Stephen Sibley
[1.1.1.1.2.4.4]
b. 19 May 1757 d. 2 Jun 1759
7
Stephen Sibley
[1.1.1.1.2.4.5]
b. 10 Nov 1759 d. 21 Apr 1829
7
Ebenezer Sibley
[1.1.1.1.2.4.6]
b. 7 Apr 1761 d. 10 Sep 1839
Lydia Beach
b. 15 May 1766 d. 6 Mar 1834
8
John Sibley
[1.1.1.1.2.4.6.1]
b. 3 Jul 1791
Nancy Kellog
b. 12 Mar 1809 d. 13 Jun 1885
9
Huldah Ann Sibley
[1.1.1.1.2.4.6.1.1]
b. 13 Dec 1839 d. 30 Aug 1874
Carlos C Martin
b. 28 Dec 1819 d. 23 Oct 1894
10
Carlos Sibley Martin
[1.1.1.1.2.4.6.1.1.1]
b. 22 Jul 1866 d. 19 Jun 1952
Sylvia Alice Hazard
b. 12 Apr 1869 d. 18 Oct 1938
11
Anna Caroline Martin
[1.1.1.1.2.4.6.1.1.1.1]
b. 16 Aug 1902 d. 22 Nov 1986
+
Albert Edward Frost
b. 19 Jan 1903 d. 21 Aug 1991
10
George Chapman Martin
[1.1.1.1.2.4.6.1.1.2]
b. 17 May 1868 d. 23 Jun 1921
+
Marrian Lane
b. 1871
9
Ebenezer Kellogg Sibley
[1.1.1.1.2.4.6.1.2]
b. 21 Sep 1841 d. 29 Sep 1895
+
Ellen Welty
b. 21 Jul 1848 d. 8 Sep 1931
9
George Whitney Sibley
[1.1.1.1.2.4.6.1.3]
b. 17 Jan 1843 d. 7 Jul 1911
Mary L Woodward
b. 21 Sep 1845 d. 1 Jan 1876
10
George Woodward Sibley
[1.1.1.1.2.4.6.1.3.1]
b. 2 Apr 1869 d. 3 Nov 1941
Louella Irene Bright
b. 25 Aug 1858 d. 23 Apr 1926
11
Luella Marie Sibley
[1.1.1.1.2.4.6.1.3.1.1]
b. 11 Oct 1895 d. 12 Apr 1984
Elmer Edgar Wilson
b. 9 Feb 1893 d. 4 Feb 1966
12
Warren Wilson
[1.1.1.1.2.4.6.1.3.1.1.1]
b. 16 Feb 1918 d. 14 Aug 2002
12
Haig Eugene Wilson
[1.1.1.1.2.4.6.1.3.1.1.2]
b. 10 Jan 1921 d. 12 Apr 1995
11
Frederick Woodward Sibley
[1.1.1.1.2.4.6.1.3.1.2]
b. 26 Jan 1912 d. 29 Jul 1925
11
George Allen Sibley
[1.1.1.1.2.4.6.1.3.1.3]
b. 14 Jan 1913 d. 23 Jul 1983
Floy Verdine Archer
b. 1 Mar 1917 d. 11 Apr 2005
12
George Allen Sibley
[1.1.1.1.2.4.6.1.3.1.3.1]
b. 26 Sep 1936 d. 4 Oct 1992
11
Edwin Sibley
[1.1.1.1.2.4.6.1.3.1.4]
b. 24 Jun 1919 d. 16 Dec 1935
Hedwig Fredrick
b. 11 Apr 1879
11
Frederick Woodward Sibley
[1.1.1.1.2.4.6.1.3.1.5]
b. 26 Jan 1912 d. 29 Jul 1925
11
George Allen Sibley
[1.1.1.1.2.4.6.1.3.1.6]
b. 14 Jan 1913 d. 23 Jul 1983
Floy Verdine Archer
b. 1 Mar 1917 d. 11 Apr 2005
12
George Allen Sibley
[1.1.1.1.2.4.6.1.3.1.6.1]
b. 26 Sep 1936 d. 4 Oct 1992
11
Edwin Sibley
[1.1.1.1.2.4.6.1.3.1.7]
b. 24 Jun 1919 d. 16 Dec 1935
10
John Whitney Sibley
[1.1.1.1.2.4.6.1.3.2]
b. 19 Jan 1875
Reteena Jasmine Sanders
b. 26 Apr 1850 d. 2 Jun 1929
10
Anna May Sibley
[1.1.1.1.2.4.6.1.3.3]
b. 28 Oct 1879 d. 4 Sep 1962
David Welty Divine
b. 9 Nov 1867 d. 11 Jul 1935
11
Elizabeth Sibley Divine
[1.1.1.1.2.4.6.1.3.3.1]
b. 8 Sep 1909 d. 30 May 1992
+
Archibald Craig Walker
b. 1 Sep 1905 d. 5 Jun 1981
11
William Welty Divine
[1.1.1.1.2.4.6.1.3.3.2]
b. 18 May 1912 d. 10 Mar 1984
+
Margaret Austin
b. 12 Aug 1909 d. 11 Feb 1992
11
George Whitney Divine
[1.1.1.1.2.4.6.1.3.3.3]
b. 30 Nov 1914 d. 27 Dec 1982
+
Madeline Alice Clark
b. 6 Nov 1918 d. 26 Mar 1958
+
Victor S Yarros
b. 8 Apr 1865 d. 30 Oct 1956
10
Elizabeth Kellogg Sibley
[1.1.1.1.2.4.6.1.3.4]
b. 29 Aug 1884 d. 6 Sep 1943
+
Edgar Allen Truby
b. 6 Dec 1872 d. 12 Mar 1921
10
John Whitney Sibley
[1.1.1.1.2.4.6.1.3.5]
b. 17 Mar 1886 d. 29 Jul 1976
+
Marion Augusta Simmons
b. Abt 1886 d. 12 Dec 1978
9
John Nelson Sibley
[1.1.1.1.2.4.6.1.4]
b. 10 Nov 1844 d. 4 Jan 1880
9
Benjamin Franklin Sibley
[1.1.1.1.2.4.6.1.5]
b. 5 Aug 1846 d. 1907
Lucia Marion Hill
b. 27 Dec 1848
10
Delia M Sibley
[1.1.1.1.2.4.6.1.5.1]
b. 1874 d. 1876
10
William H Sibley
[1.1.1.1.2.4.6.1.5.2]
b. 1877 d. 1888
10
Arthur K Sibley
[1.1.1.1.2.4.6.1.5.3]
b. 1882 d. 1888
10
Hiram W Sibley
[1.1.1.1.2.4.6.1.5.4]
b. 1884 d. 1886
10
George H Sibley
[1.1.1.1.2.4.6.1.5.5]
b. 1892 d. 1893
9
Hiram Beach Sibley
[1.1.1.1.2.4.6.1.6]
b. 4 Mar 1849 d. 20 Sep 1876
+
Mary Ann Wheeler
b. 13 Apr 1851 d. 25 Jan 1926
8
Timothy Sibley
[1.1.1.1.2.4.6.2]
b. 4 Feb 1803 d. 24 Sep 1880
7
Anna Sibley
[1.1.1.1.2.4.7]
b. 15 Dec 1762 d. 17 Sep 1792
Samuel Hoyt
b. 24 Jan 1739 d. 22 Nov 1821
8
Lydia Hoyt
[1.1.1.1.2.4.7.1]
b. 9 Apr 1779 d. Aft 1850
Jonathan Bean
b. 26 Feb 1776 d. 9 Nov 1844
9
Sopia Bean
[1.1.1.1.2.4.7.1.1]
b. 16 Jun 1799
9
Fanny Bean
[1.1.1.1.2.4.7.1.2]
b. 20 Jan 1801
9
Otis Bean
[1.1.1.1.2.4.7.1.3]
b. 26 Dec 1802
9
Asa Bean
[1.1.1.1.2.4.7.1.4]
b. 13 Mar 1805 d. 18 Apr 1856
Jane D Stone
b. 20 Jan 1820 d. 30 Jul 1896
10
Leenze Bean
[1.1.1.1.2.4.7.1.4.1]
b. 4 Sep 1840 d. 1 Mar 1841
10
Julia Ann Judson Bean
[1.1.1.1.2.4.7.1.4.2]
b. 15 Feb 1842 d. 7 Jul 1927
10
Adeniran Judson Bean
[1.1.1.1.2.4.7.1.4.3]
b. Abt 1843 d. 12 Jun 1888
+
Larzetta Anderson
b. 11 Dec 1849 d. 2 Feb 1875
+
Kate Kirkwood
10
Harriet Newell Bean
[1.1.1.1.2.4.7.1.4.4]
b. 21 Jun 1847 d. 25 Dec 1928
+
George W Simmons
10
William Gustin Bean
[1.1.1.1.2.4.7.1.4.5]
b. 8 Jan 1850 d. 5 Apr 1850
10
Fanny Jeanette Bean
[1.1.1.1.2.4.7.1.4.6]
b. 28 May 1852
Albion F Pearson
b. 1850 d. 1882
11
Nettie Alice Pearsons
[1.1.1.1.2.4.7.1.4.6.1]
b. 14 Feb 1871 d. 7 Jul 1951
John Courtenay Simmons
b. 1869
12
Ethel C Simmons
[1.1.1.1.2.4.7.1.4.6.1.1]
b. 22 Aug 1892
12
Lillian May Simmons
[1.1.1.1.2.4.7.1.4.6.1.2]
b. 2 Apr 1895
12
Jessie Reed Simmons
[1.1.1.1.2.4.7.1.4.6.1.3]
b. 22 May 1897
12
Jeanette Francis Simmons
[1.1.1.1.2.4.7.1.4.6.1.4]
b. 22 May 1897
12
Courtenay James Simmons
[1.1.1.1.2.4.7.1.4.6.1.5]
b. 4 Jan 1898
12
Robert Merrill Simmons
[1.1.1.1.2.4.7.1.4.6.1.6]
b. 13 Dec 1903
12
John Dwight Simmons
[1.1.1.1.2.4.7.1.4.6.1.7]
b. 14 Dec 1908 d. 14 Sep 1974
11
Lillian P Pearson
[1.1.1.1.2.4.7.1.4.6.2]
b. 10 Sep 1877
+
Merrill P Anthony
11
Albion N Pearson
[1.1.1.1.2.4.7.1.4.6.3]
b. 3 Dec
+
Bettie
+
J C Mann
d. 29 Oct 1897
10
Margaret Jane Bean
[1.1.1.1.2.4.7.1.4.7]
b. 6 Mar 1855
+
Vincent Francis
d. 3 Jul 1897
+
William Housel
9
Synthia Bean
[1.1.1.1.2.4.7.1.5]
b. 26 Dec 1807 d. 15 Oct 1816
9
Eliza Bean
[1.1.1.1.2.4.7.1.6]
b. 26 Dec 1807 d. 15 Oct 1816
9
Rueben C Bean
[1.1.1.1.2.4.7.1.7]
b. 2 Apr 1809
+
Elizabeth
9
Ann Bean
[1.1.1.1.2.4.7.1.8]
b. 22 May 1811
9
Mary Bean
[1.1.1.1.2.4.7.1.9]
b. 2 May 1813
9
Martha Bean
[1.1.1.1.2.4.7.1.10]
b. 15 Dec 1815 d. 6 Jan 1818
8
Anna Hoyt
[1.1.1.1.2.4.7.2]
b. 26 Sep 1781 d. 16 Sep 1865
Paulus Tenney
b. 24 Sep 1781 d. 29 Sep 1841
9
Maria Tenney
[1.1.1.1.2.4.7.2.1]
b. 4 Jun 1805 d. 1 May 1812
9
Franklin Tenney
[1.1.1.1.2.4.7.2.2]
b. 5 Nov 1806 d. 15 Nov 1878
9
Nancy S Tenney
[1.1.1.1.2.4.7.2.3]
b. 28 Oct 1808 d. 1885
James French
b. 1 Apr 1815
10
Rebecca Ann French
[1.1.1.1.2.4.7.2.3.1]
b. 26 Jan 1838
10
James Paulus French
[1.1.1.1.2.4.7.2.3.2]
b. 4 Apr 1840
10
Mary Elizabeth French
[1.1.1.1.2.4.7.2.3.3]
b. 24 Aug 1842
+
Oscar E Boyd
b. Abt 1838
10
Jonathan John French
[1.1.1.1.2.4.7.2.3.4]
b. 31 Jan 1845
10
Samuel S French
[1.1.1.1.2.4.7.2.3.5]
b. 21 Dec 1847 d. 12 Jan 1851
10
William Harris French
[1.1.1.1.2.4.7.2.3.6]
b. 29 Oct 1850 d. 11 Jan 1851
10
Solon Tenney French
[1.1.1.1.2.4.7.2.3.7]
b. 15 Oct 1851 d. 27 Dec 1908
+
Laura Augusta Shumway
b. 21 Aug 1854
9
Sylvainus Tenny
[1.1.1.1.2.4.7.2.4]
b. 6 Oct 1810 d. 12 Oct 1888
Mary Jane Bay
b. 21 Mar 1818
10
Paul Hugh Tenney
[1.1.1.1.2.4.7.2.4.1]
b. 1 May 1839 d. 29 Sep 1868
Angeline
b. Abt 1843
11
Mary Tenney
[1.1.1.1.2.4.7.2.4.1.1]
b. 1864
11
George S Tenney
[1.1.1.1.2.4.7.2.4.1.2]
b. 1866
10
Arkalon Tenney
[1.1.1.1.2.4.7.2.4.2]
b. 26 Jun 1841
Margaret Shields
b. Abt 1841
11
Laura A Tenney
[1.1.1.1.2.4.7.2.4.2.1]
b. 4 Dec 1860 d. 29 Aug 1876
11
Hosea Eugene Tenney
[1.1.1.1.2.4.7.2.4.2.2]
b. 28 Mar 1863 d. 7 Dec 1936
May Estella Brown
b. 10 Oct 1873 d. 13 Aug 1961
12
Harold E Tenney
[1.1.1.1.2.4.7.2.4.2.2.1]
b. 20 Dec 1908
12
Loren B Tenney
[1.1.1.1.2.4.7.2.4.2.2.2]
b. 20 Dec 1908 d. 28 Aug 1910
12
Ruth Rosalia Tenney
[1.1.1.1.2.4.7.2.4.2.2.3]
b. 25 May 1911 d. 27 Jul 2008
12
Ruby Rosetta Tenny
[1.1.1.1.2.4.7.2.4.2.2.4]
b. 25 May 1911 d. 28 May 2006 [
=>
]
11
William Sheridan Tenney
[1.1.1.1.2.4.7.2.4.2.3]
b. 8 Oct 1865 d. 7 Oct 1876
11
Mary Eliza Tenney
[1.1.1.1.2.4.7.2.4.2.4]
b. 21 Feb 1868
+
James M Haney
11
Leila May Tenney
[1.1.1.1.2.4.7.2.4.2.5]
b. 23 Feb 1871
+
John W Borah
b. 14 Jan 1872
11
Mattie A Tenney
[1.1.1.1.2.4.7.2.4.2.6]
b. 25 Oct 1874
+
W L Decker
11
James Garfield Morton Tenney
[1.1.1.1.2.4.7.2.4.2.7]
b. 7 Nov 1881 d. 1970
10
Curtis Monroe Tenney
[1.1.1.1.2.4.7.2.4.3]
b. 2 Aug 1847 d. 10 Dec 1850
10
William Lafayette Tenney
[1.1.1.1.2.4.7.2.4.4]
b. 30 Apr 1851
Mary Ann Turner
b. Jun 1851
11
Leslie Edward Tenney
[1.1.1.1.2.4.7.2.4.4.1]
b. 5 Dec 1873
+
Anna Barbara Louis
b. 16 Apr 1876
+
Pansy Zula Cochran
b. 15 Apr 1892 d. 5 Jul 1969
11
Lieuellon Tenney
[1.1.1.1.2.4.7.2.4.4.2]
b. Jun 1875
11
Gracy A Tenney
[1.1.1.1.2.4.7.2.4.4.3]
b. Feb 1880
11
William L Tenney
[1.1.1.1.2.4.7.2.4.4.4]
b. Feb 1883
11
Minnie M Tenney
[1.1.1.1.2.4.7.2.4.4.5]
b. Oct 1885
11
Mary J Tenney
[1.1.1.1.2.4.7.2.4.4.6]
b. Jun 1889
11
Hershel A Tenney
[1.1.1.1.2.4.7.2.4.4.7]
b. Apr 1891
11
Beatrice Leone Tenney
[1.1.1.1.2.4.7.2.4.4.8]
b. 6 Jun 1893
+
Arthur Edward Knapp
b. 18 Feb 1893 d. Dec 1976
10
Zilpha Tenney
[1.1.1.1.2.4.7.2.4.5]
b. 1853 d. 1856
10
Mary Mariah Tenney
[1.1.1.1.2.4.7.2.4.6]
b. 4 Sep 1844 d. 15 Jan 1933
Isaac Wood
b. 6 May 1843 d. 1 May 1927
11
Nettie Ambrosia Wood
[1.1.1.1.2.4.7.2.4.6.1]
b. 10 Nov 1863 d. 31 Oct 1892
+
Frank R Kirkpatric
11
Effie Alberta Wood
[1.1.1.1.2.4.7.2.4.6.2]
b. 19 Jul 1866
Joseph Vinton Blake
b. 11 Jul 1866 d. Jun 1956
12
Blanch Blake
[1.1.1.1.2.4.7.2.4.6.2.1]
b. 21 Feb 1900 d. 30 Apr 1985
11
Ivia Jane Wood
[1.1.1.1.2.4.7.2.4.6.3]
b. 1870 d. 1963
+
Arthur Lindsey Earl
b. Abt 1870
11
Earnest Doric Wood
[1.1.1.1.2.4.7.2.4.6.4]
b. 20 Jan 1874 d. 1939
+
Minnei Burch
11
Arkalon John Wood
[1.1.1.1.2.4.7.2.4.6.5]
b. 24 Dec 1875 d. 2 Feb 1958
Hattie Leona Todd
b. 23 Nov 1878 d. 15 Apr 1937
12
Earl Emmerson Wood
[1.1.1.1.2.4.7.2.4.6.5.1]
b. 12 Mar 1907 d. 24 Jul 2000 [
=>
]
12
Ralph Waldo Wood
[1.1.1.1.2.4.7.2.4.6.5.2]
b. 25 Dec 1909 d. 29 Dec 1979 [
=>
]
12
Marine Leona Wood
[1.1.1.1.2.4.7.2.4.6.5.3]
b. 26 Jul 1912 d. 1 Jan 2007
11
Lillian Grace Wood
[1.1.1.1.2.4.7.2.4.6.6]
b. 24 Jan 1879 d. 24 Jan 1879
11
Bessie Kate Wood
[1.1.1.1.2.4.7.2.4.6.7]
b. 13 Dec 1881 d. 12 Nov 1977
Jacob George Hershner
b. 18 Mar 1860 d. 16 Nov 1951
12
Zilpha Maud Hershner
[1.1.1.1.2.4.7.2.4.6.7.1]
b. 4 Jul 1906 d. 25 Dec 2009 [
=>
]
11
Zilpha L Wood
[1.1.1.1.2.4.7.2.4.6.8]
b. 1883 d. 30 Jun 1986
+
Charles Spears
11
Adda May Wood
[1.1.1.1.2.4.7.2.4.6.9]
b. 1883
10
James F Tenney
[1.1.1.1.2.4.7.2.4.7]
b. 1856
Martha Ann Austin
b. Jul 1857
11
Maud Tenney
[1.1.1.1.2.4.7.2.4.7.1]
b. Oct 1877
11
Sylvanus Tenney
[1.1.1.1.2.4.7.2.4.7.2]
b. Mar 1879
11
Martin Tenney
[1.1.1.1.2.4.7.2.4.7.3]
b. Jul 1883
11
Frank Tenney
[1.1.1.1.2.4.7.2.4.7.4]
b. Dec 1885
11
Otha Tenney
[1.1.1.1.2.4.7.2.4.7.5]
b. Aug 1888
11
Edmund Tenney
[1.1.1.1.2.4.7.2.4.7.6]
b. Feb 1890
11
Florence M Tenney
[1.1.1.1.2.4.7.2.4.7.7]
b. Dec 1894
8
William Hoyt
[1.1.1.1.2.4.7.3]
b. 24 Jul 1783 d. 19 Feb 1813
Polly French
b. Abt 1785
9
Freeman Hoyt
[1.1.1.1.2.4.7.3.1]
b. 1805
9
Mary French Hoyt
[1.1.1.1.2.4.7.3.2]
b. Abt 1809
+
Cheney
b. Abt 1845
9
Sewell Hoyt
[1.1.1.1.2.4.7.3.3]
b. Abt 1811
9
William Hoyt
[1.1.1.1.2.4.7.3.4]
b. Abt 1813
9
French Hoyt
[1.1.1.1.2.4.7.3.5]
b. Abt 1815
8
Sarah Hoyt
[1.1.1.1.2.4.7.4]
b. 13 Feb 1786 d. 14 Nov 1862
John Hoyt
b. 2 Dec 1787
9
Sophronia Hoyt
[1.1.1.1.2.4.7.4.1]
b. 21 Dec 1810 d. 12 Feb 1889
Joel Blackman
b. 21 Dec 1810 d. 22 Jun 1901
10
True Worthy Blackman
[1.1.1.1.2.4.7.4.1.1]
b. 27 Nov 1836 d. 16 Jan 1925
Amelia Fanny Kennedy
b. 10 Jul 1848 d. 8 Dec 1914
11
Albert Joseph Blackman
[1.1.1.1.2.4.7.4.1.1.1]
b. 14 Oct 1873 d. 15 Sep 1962
11
Alexander Frances Blackman
[1.1.1.1.2.4.7.4.1.1.2]
b. 5 May 1876
Camille Clarice Dynan
b. Abt 1890
12
Living
[1.1.1.1.2.4.7.4.1.1.2.1]
10
John Monroe Blackman
[1.1.1.1.2.4.7.4.1.2]
b. 1852 d. 7 Jun 1871
10
Virgil W Blackman
[1.1.1.1.2.4.7.4.1.3]
b. 3 Jul 1857 d. 1921
Delle Lucretia Butler
b. Apr 1862 d. 1959
11
Hattie Blackman
[1.1.1.1.2.4.7.4.1.3.1]
b. 2 Jan 1891
9
William Hoyt
[1.1.1.1.2.4.7.4.2]
b. 12 Oct 1813
+
Mrs Hoyt
9
Samuel True Hoyt
[1.1.1.1.2.4.7.4.3]
b. Abt 1814
9
True Worthy Hoyt
[1.1.1.1.2.4.7.4.4]
b. 31 Aug 1815 d. 1900
Phebe Ann Jameson
b. 1820
10
Phoebe Sophronia Hoyt
[1.1.1.1.2.4.7.4.4.1]
b. 12 May 1847 d. 4 Aug 1849
10
Sarah Elizabeth Hoyt
[1.1.1.1.2.4.7.4.4.2]
b. 16 Aug 1850 d. 22 Jan 1855
10
True Worthy Hoit
[1.1.1.1.2.4.7.4.4.3]
b. 15 May 1853
+
Louisa Catherine M. Murenberg
10
Elisabeth Jamison Hoit
[1.1.1.1.2.4.7.4.4.4]
b. 16 Jun 1856
+
William H S Thorburn
10
Homer A Hoit
[1.1.1.1.2.4.7.4.4.5]
b. 17 Dec 1858 d. 28 Feb 1923
+
Florence E Hickey
10
Fanny Story Hoyt
[1.1.1.1.2.4.7.4.4.6]
b. 19 Oct 1861
9
Albert Lewis Hoyt
[1.1.1.1.2.4.7.4.5]
b. 23 Dec 1822 d. 10 Aug 1843
7
Asa Sibley
[1.1.1.1.2.4.8]
b. 29 Mar 1764 d. 25 Feb 1829
Irene Carpenter
b. 28 Jan 1766 d. 5 Oct 1846
8
Derick Sibley
[1.1.1.1.2.4.8.1]
b. 22 May 1788 d. Abt 1846
Rachael Roberts
b. 1800 d. Aft 1860
9
Caroline Sibley
[1.1.1.1.2.4.8.1.1]
b. 1833 d. Aft 1860
W L Evans
b. 1827 d. Aft 1860
10
Anna B Evans
[1.1.1.1.2.4.8.1.1.1]
b. 1852 d. Aft 1860
8
Sophia Sibley
[1.1.1.1.2.4.8.2]
b. 5 Oct 1790 d. 4 Feb 1841
Oren Hall
b. 1789 d. Dec 1820
9
Sophia Edna Hall
[1.1.1.1.2.4.8.2.1]
b. 1 Apr 1809 d. 1870
Edwin Thomson
b. 1808 d. Abt 1857
10
Mortimer Neal Thomson
[1.1.1.1.2.4.8.2.1.1]
b. 2 Sep 1831 d. 25 Jun 1875
Anna Houston VanCleve
b. 1840 d. Dec 1858
11
Mark VanCleve Thomson
[1.1.1.1.2.4.8.2.1.1.1]
b. 1859
Grace Harrington Eldredge
b. 24 Feb 1841 d. 13 Dec 1862
11
Ethel Thomson
[1.1.1.1.2.4.8.2.1.1.2]
b. 1 Dec 1862 d. 1944
10
Clifford Thomson
[1.1.1.1.2.4.8.2.1.2]
b. 15 Apr 1834 d. 29 Sep 1912
Sarah Maria Dutton
b. 1844 d. 23 Oct 1934
11
Clifford Thomson
[1.1.1.1.2.4.8.2.1.2.1]
b. 1868 d. Bef 1880
11
Florence F Thomson
[1.1.1.1.2.4.8.2.1.2.2]
b. 13 Jun 1869 d. 27 Jul 1939
11
Winifred E Thomson
[1.1.1.1.2.4.8.2.1.2.3]
b. 22 Feb 1871 d. 26 Jun 1950
+
John L Lockwood
b. Abt 1875 d. Aft 1920
9
Edwin Oscar Hall
[1.1.1.1.2.4.8.2.2]
b. 21 Oct 1810 d. 19 Sep 1883
Sarah Lyon Williams
b. 27 Oct 1812 d. 15 Aug 1876
10
Sophia Elizabeth Hall
[1.1.1.1.2.4.8.2.2.1]
b. 4 Jul 1836 d. 26 May 1863
William White
b. 28 Feb 1837 d. 8 May 1896
11
Lucy Sophia White
[1.1.1.1.2.4.8.2.2.1.1]
b. 25 Mar 1861 d. 25 Apr 1891
Frank Herbert Palmer
b. 6 Mar 1853 d. 1936
12
Herbert Hall Palmer
[1.1.1.1.2.4.8.2.2.1.1.1]
b. 20 Jul 1884 d. 14 Nov 1970 [
=>
]
12
Cleaveland Allison Palmer
[1.1.1.1.2.4.8.2.2.1.1.2]
b. 15 Jul 1887 d. 18 Jul 1908
12
Helen Palmer
[1.1.1.1.2.4.8.2.2.1.1.3]
b. 11 Sep 1889
12
Gladys Freeman Palmer
[1.1.1.1.2.4.8.2.2.1.1.4]
b. 11 Sep 1889 d. Nov 1977
11
Edwin Oscar White
[1.1.1.1.2.4.8.2.2.1.2]
b. 6 May 1863 d. 9 Jun 1940
Ella Louise Street
b. 16 Mar 1860 d. 6 Feb 1887
12
Clifford Franklin White
[1.1.1.1.2.4.8.2.2.1.2.1]
b. 3 Aug 1885 d. 30 Dec 1973 [
=>
]
Anna Caroline Austin
b. 15 Feb 1864 d. 16 Jan 1934
12
Henry Austin White
[1.1.1.1.2.4.8.2.2.1.2.2]
b. 3 Sep 1889 d. 25 Apr 1939 [
=>
]
12
Austin Hall White
[1.1.1.1.2.4.8.2.2.1.2.3]
b. 9 Dec 1892 d. 29 Jan 1960 [
=>
]
+
Lillian May Richardson
b. 9 Jan 1869 d. 7 Dec 1951
10
Caroline Alice Hall
[1.1.1.1.2.4.8.2.2.2]
b. 5 Nov 1839 d. 29 Jan 1868
10
William Wisner Hall
[1.1.1.1.2.4.8.2.2.3]
b. 1 Jun 1841 d. 23 May 1910
Elizabeth Archer VanCleve
b. 25 Nov 1846 d. 27 Jun 1918
11
William Sibley Hall
[1.1.1.1.2.4.8.2.2.3.1]
b. 30 Jan 1867 d. 19 Oct 1868
11
Horatio VanCleve Hall
[1.1.1.1.2.4.8.2.2.3.2]
b. 15 Jan 1871 d. 20 Aug 1889
11
Charlotte VanCleve Hall
[1.1.1.1.2.4.8.2.2.3.3]
b. 31 Jul 1876 d. 23 May 1969
11
Theodore Seymour Hall
[1.1.1.1.2.4.8.2.2.3.4]
b. 16 Feb 1880 d. 6 Mar 1963
Ruth Houghton
b. 12 Feb 1885 d. 10 Jan 1972
12
Houghton Seymour Hall
[1.1.1.1.2.4.8.2.2.3.4.1]
b. 17 Nov 1910 d. 10 Jan 2002
12
Winslow William Hall
[1.1.1.1.2.4.8.2.2.3.4.2]
b. 15 May 1912 d. 27 Dec 1995
11
Edwin Oscar Hall
[1.1.1.1.2.4.8.2.2.3.5]
b. 30 May 1881 d. 28 Oct 1946
Margaret Brown
b. 8 Jun 1881 d. 7 Aug 1973
12
Thomas Seymour Hall
[1.1.1.1.2.4.8.2.2.3.5.1]
b. 13 Oct 1916 d. 27 Dec 1998
11
Florence Hall
[1.1.1.1.2.4.8.2.2.3.6]
b. 18 May 1884 d. 9 Mar 1982
Malcolm MacIntyre
b. 15 Jun 1879 d. 24 Aug 1934
12
Cornelia Hall MacIntyre
[1.1.1.1.2.4.8.2.2.3.6.1]
b. 31 Jan 1909 d. 18 Jan 2010
12
Jean Elizabeth MacIntyre
[1.1.1.1.2.4.8.2.2.3.6.2]
b. 16 Jul 1911 d. 12 Nov 1993
12
Margery Seymour MacIntyre
[1.1.1.1.2.4.8.2.2.3.6.3]
b. 14 Dec 1914 d. 28 Jan 2007
12
Malcolm Neil MacIntyre
[1.1.1.1.2.4.8.2.2.3.6.4]
b. 12 Aug 1919 d. 4 Oct 1997
11
Philip Cushman Hall
[1.1.1.1.2.4.8.2.2.3.7]
b. 11 Dec 1886 d. 28 Apr 1972
+
May Christine Gilmour
b. 27 Jun 1880 d. 9 Mar 1958
+
Jane Bailey Rittenhouse
b. 15 Jan 1915 d. 16 Jul 1980
10
Cornelia Hall
[1.1.1.1.2.4.8.2.2.4]
b. 25 Aug 1842 d. 27 Apr 1911
Peter Cushman Jones
b. 10 Dec 1837 d. 23 Apr 1922
11
Edwin Austin Jones
[1.1.1.1.2.4.8.2.2.4.1]
b. 11 May 1863 d. 10 Jul 1898
Isabella McCracken "Belle" Fuller
b. 15 Mar 1868 d. 31 Mar 1944
12
Edwin Austin Jones
[1.1.1.1.2.4.8.2.2.4.1.1]
b. 8 Sep 1889 d. 9 Jul 1947 [
=>
]
12
Helen Jones
[1.1.1.1.2.4.8.2.2.4.1.2]
b. 8 Jan 1894 d. 1990
12
Margaret Jones
[1.1.1.1.2.4.8.2.2.4.1.3]
b. 25 Jun 1895 d. 4 Dec 1970 [
=>
]
12
Catherine Hay Jones
[1.1.1.1.2.4.8.2.2.4.1.4]
b. 3 Oct 1897 d. Dec 1985
11
Ada Jones
[1.1.1.1.2.4.8.2.2.4.2]
b. 28 Oct 1869 d. 28 Jun 1950
Alonzo Gartley
b. 14 Oct 1869 d. 21 Apr 1921
12
Eleanor Gartley
[1.1.1.1.2.4.8.2.2.4.2.1]
b. 4 Aug 1897 d. 21 Jun 1988 [
=>
]
12
Ruth Gartley
[1.1.1.1.2.4.8.2.2.4.2.2]
b. 18 Dec 1898 d. 13 Aug 1967
12
Richard Hall Gartley
[1.1.1.1.2.4.8.2.2.4.2.3]
b. 12 Jun 1901 d. 1983
12
Alonzo Gartley
[1.1.1.1.2.4.8.2.2.4.2.4]
b. 3 Jun 1904 d. 12 Apr 1991
11
Alice Hall Jones
[1.1.1.1.2.4.8.2.2.4.3]
b. 2 Jan 1880 d. 10 Oct 1974
+
Mary Lyon Dame
b. 6 Oct 1848 d. 16 Mar 1908
9
Asa Sibley Hall
[1.1.1.1.2.4.8.2.3]
b. 23 Apr 1818
Joseph Willard Seymour
b. 29 Mar 1781 d. 25 Jan 1867
9
Oren T Seymour
[1.1.1.1.2.4.8.2.4]
b. 1824
9
Mary E. Seymour
[1.1.1.1.2.4.8.2.5]
b. Abt 1825 d. Aft 1850
9
Theodore S. Seymour
[1.1.1.1.2.4.8.2.6]
b. 1 Jul 1828 d. 1902
8
Lucy Sibley
[1.1.1.1.2.4.8.3]
b. 21 Jul 1792 d. 18 Jul 1795
8
Levi Waite Sibley
[1.1.1.1.2.4.8.4]
b. 4 Mar 1801 d. 13 Aug 1844
Nancy Ann Remington
b. 18 Sep 1801 d. 9 Jan 1870
9
Augustus Furburt Sibley
[1.1.1.1.2.4.8.4.1]
b. 15 Jul 1827
Mary Williamsen Ogden
b. 20 May 1838 d. 15 Jan 1890
10
Herman Clark Sibley
[1.1.1.1.2.4.8.4.1.1]
b. 22 Nov 1860
9
Amanda Maria Sibley
[1.1.1.1.2.4.8.4.2]
b. 25 Oct 1829 d. 31 Mar 1861
John Francis Hoyt
b. 18 Oct 1816
10
Harriet M Hoyt
[1.1.1.1.2.4.8.4.2.1]
b. 19 Oct 1849
9
William Wisner Sibley
[1.1.1.1.2.4.8.4.3]
b. 4 Feb 1831 d. 30 Jun 1870
+
Helen Jane Wilcox
b. 31 Aug 1831
9
Harriet Remington Sibley
[1.1.1.1.2.4.8.4.4]
b. 12 Jul 1833 d. Aug 1844
9
George Ainsworth Sibley
[1.1.1.1.2.4.8.4.5]
b. 13 Jun 1834 d. 29 Dec 1856
9
Levi Edwin Sibley
[1.1.1.1.2.4.8.4.6]
b. 8 Sep 1839 d. 29 Oct 1900
Sarah Ella Martling
b. Oct 1852 d. 28 Dec 1932
10
Lucy M Sibley
[1.1.1.1.2.4.8.4.6.1]
b. 1876 d. 1888
10
William W Sibley
[1.1.1.1.2.4.8.4.6.2]
b. Dec 1877
Florence Z Parsons
b. 1883
11
Edwin Gerald Sibley
[1.1.1.1.2.4.8.4.6.2.1]
b. 4 Apr 1906 d. Dec 1963
+
Alice Kipp Tuthill
b. 20 Sep 1906 d. 15 Feb 1995
11
Frederick Warren Sibley
[1.1.1.1.2.4.8.4.6.2.2]
b. 1907 d. 1941
11
William Parsons Sibley
[1.1.1.1.2.4.8.4.6.2.3]
b. 1909 d. 1967
11
George E Sibley
[1.1.1.1.2.4.8.4.6.2.4]
b. 1914
10
George Edwin Sibley
[1.1.1.1.2.4.8.4.6.3]
b. 24 Jun 1881
8
Mary Ann Sibley
[1.1.1.1.2.4.8.5]
b. 18 Dec 1804 d. 18 Oct 1870
Edwin Scrantom
b. 9 May 1803 d. 3 Oct 1880
9
Stella Benton Scrantom
[1.1.1.1.2.4.8.5.1]
b. 12 Jan 1827
+
Galusha Phillips
b. 27 Apr 1820 d. 1880
9
Adrian George Scrantom
[1.1.1.1.2.4.8.5.2]
b. 26 Oct 1828 d. 1880
+
Mary Sheldon
b. Abt 1832
+
Charlotta
d. 1880
+
Helen Jane Wilcox
b. 31 Aug 1831 d. Abt 1900
9
Cora Irene Scrantom
[1.1.1.1.2.4.8.5.3]
b. 28 Jun 1830 d. 31 Dec 1858
John E Sabine
b. Abt 1826 d. 7 Jul 1854
10
Cora Lovisa Sabine
[1.1.1.1.2.4.8.5.3.1]
b. 30 Jan 1850
10
Mary Irene Sabine
[1.1.1.1.2.4.8.5.3.2]
b. 8 Jan 1853
Franklin Earl Childs
b. 16 Oct 1848
11
Emalita Phillips Childs
[1.1.1.1.2.4.8.5.3.2.1]
b. 21 Oct 1879
11
Daniel B Childs
[1.1.1.1.2.4.8.5.3.2.2]
b. 18 Sep 1881
10
Sibly Phillips Sabine
[1.1.1.1.2.4.8.5.3.3]
b. 23 Dec 1854
George Williams
b. 24 Nov 1831 d. 10 Feb 1895
10
Child Williams
[1.1.1.1.2.4.8.5.3.4]
b. 31 Dec 1858 d. 31 Dec 1858
9
Edwina Jane Scrantom
[1.1.1.1.2.4.8.5.4]
b. 24 Sep 1832 d. Abt 1839
9
Hamlet Edwin Scrantom
[1.1.1.1.2.4.8.5.5]
b. Abt 1833 d. Abt 1833
9
Beulah Mary Scrantom
[1.1.1.1.2.4.8.5.6]
b. 15 Jan 1835 d. 1 Jan 1900
Isaac H Weaver
b. Abt 1831 d. Bef 1867
10
Edwin James Weaver
[1.1.1.1.2.4.8.5.6.1]
b. 1857 d. 12 Aug 1874
Ensley Mills Smith
b. 8 Aug 1828 d. 7 May 1886
10
Emmalita A Smith
[1.1.1.1.2.4.8.5.6.2]
b. 12 Apr 1868 d. 29 Sep 1879
10
Mary Elizabeth Smith
[1.1.1.1.2.4.8.5.6.3]
b. 6 Jul 1870 d. 13 Oct 1879
10
Ensley Boyd Smith
[1.1.1.1.2.4.8.5.6.4]
b. 10 Jan 1876 d. 7 Aug 1956
+
Stella Louisa Jerome
b. 6 May 1876 d. 8 Feb 1955
9
Edwin Levi Scrantom
[1.1.1.1.2.4.8.5.7]
b. Abt 1837 d. Abt 1837
9
Clifford Sibley Scrantom
[1.1.1.1.2.4.8.5.8]
b. Abt 1841 d. Abt 1844
9
Melford Clark Scrantom
[1.1.1.1.2.4.8.5.9]
b. 4 Nov 1844 d. Abt 1845
9
Bertha Sibley Scranton
[1.1.1.1.2.4.8.5.10]
b. 29 Nov 1848
8
George Ainsworth Sibley
[1.1.1.1.2.4.8.6]
b. 9 Apr 1809 d. 1 Jun 1836
8
Daughter Sibley
[1.1.1.1.2.4.8.7]
c. 1 Oct 1809 d. 1809
7
Jonathan Sibley
[1.1.1.1.2.4.9]
b. 8 May 1766 d. 20 Feb 1823
Mary Davis
b. 24 Feb 1768 d. 23 Jun 1840
8
Davis Sibley
[1.1.1.1.2.4.9.1]
b. 29 Nov 1788 d. 21 Nov 1828
Cynta Fisher
b. Abt 1797 d. 6 Jul 1874
9
Nelson Sibley
[1.1.1.1.2.4.9.1.1]
b. 4 Mar 1820 d. 10 Mar 1850
9
Franklin Sibley
[1.1.1.1.2.4.9.1.2]
b. 1 Oct 1821 d. 1878
Julia Badger Leavitt
b. 29 Jul 1826 d. 28 Jan 1864
10
Mary Sibley
[1.1.1.1.2.4.9.1.2.1]
b. 1847
10
Frederick M Sibley
[1.1.1.1.2.4.9.1.2.2]
b. Jun 1849 d. 2 Oct 1912
10
Davis Origin Sibley
[1.1.1.1.2.4.9.1.2.3]
b. 28 Jun 1853 d. 22 May 1913
10
George F Sibley
[1.1.1.1.2.4.9.1.2.4]
b. Sep 1853
10
Walter Frank Sibley
[1.1.1.1.2.4.9.1.2.5]
b. Sep 1857 d. 4 Jun 1911
Clara Greenwood Beecher
b. 6 Feb 1857 d. 21 Sep 1949
11
Chester L Sibley
[1.1.1.1.2.4.9.1.2.5.1]
b. 1882 d. 1884
11
Maurice Sibley
[1.1.1.1.2.4.9.1.2.5.2]
b. 1886 d. 1894
11
Frank Sibley
[1.1.1.1.2.4.9.1.2.5.3]
b. 1888 d. 1890
11
Hazel Sibley
[1.1.1.1.2.4.9.1.2.5.4]
b. 27 Jun 1892 d. 10 Feb 1948
+
Ian Alexander Armstrong
b. 13 Jan 1887 d. 16 Nov 1953
11
Gladys L Sibley
[1.1.1.1.2.4.9.1.2.5.5]
b. 1896 d. 1928
10
John L Sibley
[1.1.1.1.2.4.9.1.2.6]
b. 1859
Ellen W Floyd
b. 1836 d. 1 Jul 1878
10
Ernia M Sibley
[1.1.1.1.2.4.9.1.2.7]
b. Jun 1878 d. 12 Jul 1878
10
Ena L Sibley
[1.1.1.1.2.4.9.1.2.8]
b. Jun 1878 d. 30 Jun 1878
9
Laura Messenger Sibley
[1.1.1.1.2.4.9.1.3]
b. 6 Dec 1822 d. 13 Jan 1861
9
Mary Sibley
[1.1.1.1.2.4.9.1.4]
b. 15 Apr 1825 d. 21 Aug 1826
9
Martha Sibley
[1.1.1.1.2.4.9.1.5]
b. 18 Jun 1826 d. Sep 1826
9
Mary Sibley
[1.1.1.1.2.4.9.1.6]
b. 7 Aug 1827 d. 16 Oct 1840
9
Caroline F Sibley
[1.1.1.1.2.4.9.1.7]
b. 14 Dec 1828 d. 7 Apr 1853
+
Cyrus Harris
8
Mary Sibley
[1.1.1.1.2.4.9.2]
b. 13 Apr 1792 d. 9 Nov 1844
Augustine White
b. 19 Jan 1777
9
Mary Ann White
[1.1.1.1.2.4.9.2.1]
b. 19 Apr 1812 d. 12 May 1823
9
Eliza Malvina White
[1.1.1.1.2.4.9.2.2]
b. 30 Nov 1814 d. 7 Apr 1858
+
Henry W Nichols
9
Cynthia Sibley White
[1.1.1.1.2.4.9.2.3]
b. 8 May 1818
9
Augusta Holven White
[1.1.1.1.2.4.9.2.4]
b. 28 Jan 1821
+
Daniel Scott
9
Lucy Violy White
[1.1.1.1.2.4.9.2.5]
b. 20 Oct 1824 d. Jul 1845
9
John S White
[1.1.1.1.2.4.9.2.6]
b. 2 Jul 1827
+
Emilie Jouret
9
Davis J White
[1.1.1.1.2.4.9.2.7]
b. 27 Jan 1833
8
Jonathan W Sibley
[1.1.1.1.2.4.9.3]
b. 13 Aug 1800 d. 26 Sep 1829
Brooksey Case
b. 30 Sep 1804 d. 15 Mar 1829
9
Albert C Sibley
[1.1.1.1.2.4.9.3.1]
b. 3 Jun 1828 d. Feb 1852
7
Benjamin Sibley
[1.1.1.1.2.4.10]
b. 29 Apr 1768 d. 2 Oct 1829
Zilpah Davis
b. 13 Apr 1771 d. 16 May 1824
8
Samuel Sibley
[1.1.1.1.2.4.10.1]
b. 30 Nov 1792 d. 4 Mar 1858
Lucinda Holbrock
b. 19 Mar 1806 d. 2 Mar 1830
9
Giles H Sibley
[1.1.1.1.2.4.10.1.1]
b. 26 May 1825 d. 10 Jun 1825
9
Morella Sibley
[1.1.1.1.2.4.10.1.2]
b. 19 Jun 1827 d. 31 Jul 1849
9
Lucinda Sibley
[1.1.1.1.2.4.10.1.3]
b. 12 Jul 1829 d. 4 Sep 1854
Almira Dixon
b. 3 Apr 1807
9
Elizabeth H Sibley
[1.1.1.1.2.4.10.1.4]
b. 20 Nov 1833
+
Joseph Fisk
9
Mary Sibley
[1.1.1.1.2.4.10.1.5]
b. 16 Jan 1838 d. 17 Aug 1839
9
Helen Sibley
[1.1.1.1.2.4.10.1.6]
b. 23 Sep 1842 d. 3 Feb 1844
9
George H Sibley
[1.1.1.1.2.4.10.1.7]
b. 25 Aug 1845
+
Theodocia Townsend
8
Patty Sibley
[1.1.1.1.2.4.10.2]
b. 6 Feb 1799 d. 12 Jul 1805
8
Nancy Sibley
[1.1.1.1.2.4.10.3]
b. 7 Feb 1806 d. 14 Feb 1806
8
Hiram Sibley
[1.1.1.1.2.4.10.4]
b. 6 Feb 1807 d. 12 Jul 1888
Elizabeth Maria Tinker
b. 11 Aug 1815 d. 11 Jul 1903
9
Zilpha Louisa Sibley
[1.1.1.1.2.4.10.4.1]
b. 7 Dec 1833 d. 16 Jun 1868
Hobart Ford Atkinson
b. 5 Oct 1825 d. 14 Aug 1908
10
Marie Louise Atkinson
[1.1.1.1.2.4.10.4.1.1]
b. 24 Feb 1864 d. 29 Oct 1940
+
Gilman Henry Hubbell Perkins
b. 2 Nov 1861 d. 12 Mar 1894
+
Ernest Russell Willard
b. 11 Mar 1854 d. 6 May 1937
10
Elizabeth Storer Atkinson
[1.1.1.1.2.4.10.4.1.2]
b. Abt 1866 bur. 16 Feb 1945
9
Giles Benjamin Sibley
[1.1.1.1.2.4.10.4.2]
b. 8 Apr 1841 d. 14 Mar 1843
9
Hiram Watson Sibley
[1.1.1.1.2.4.10.4.3]
b. 2 Mar 1845 d. 28 Jun 1932
Margaret Durbin Harper
b. 14 Feb 1852 d. 28 May 1939
10
Margaret Harper Sibley
[1.1.1.1.2.4.10.4.3.1]
b. 14 Dec 1873 d. 30 Nov 1874
10
Hiram Sibley
[1.1.1.1.2.4.10.4.3.2]
b. 24 Jul 1875 d. 12 Apr 1886
10
John Durbin Sibley
[1.1.1.1.2.4.10.4.3.3]
b. 3 Nov 1883 d. 18 Sep 1888
10
Fletcher Harper Sibley
[1.1.1.1.2.4.10.4.3.4]
b. 5 Apr 1885 d. 24 Apr 1959
Georgianna Harding Farr
b. 30 May 1887 d. 10 Jun 1980
11
Jane Harper Sibley
[1.1.1.1.2.4.10.4.3.4.1]
b. 27 Jul 1918 d. 5 Feb 2006
+
Gordon Auchincloss
b. 11 May 1917 d. 1 Jun 1998
10
Margaret Urling Sibley
[1.1.1.1.2.4.10.4.3.5]
b. 17 Jan 1893 d. 3 Apr 1951
+
O'Donnell Iselin
b. 6 Oct 1884 d. 7 Nov 1971
9
Emily Sibley
[1.1.1.1.2.4.10.4.4]
b. 10 May 1855 d. 8 Feb 1945
Isaac Seymour Averill
b. 21 Jun 1850 d. 25 Oct 1909
10
Elizabeth Louise Averell
[1.1.1.1.2.4.10.4.4.1]
b. 25 Jan 1877 d. 2 Apr 1886
10
James G Averell
[1.1.1.1.2.4.10.4.4.2]
b. 23 Dec 1877 d. 30 Nov 1904
James Sibley Watson
b. 11 Mar 1860 d. 1951
10
James Sibley "Sibley" Watson, Jr
[1.1.1.1.2.4.10.4.4.3]
b. 10 Aug 1894 d. 31 Mar 1982
Hildegarde Lasell
b. 28 Dec 1888 d. 1976
11
Michael Lasell Watson
[1.1.1.1.2.4.10.4.4.3.1]
b. 2 Jan 1918 d. 26 Nov 2012
+
Nicoleta Zervas
b. 12 Sep 1927 d. 11 Feb 2011
11
Jeanne Iseult Watson
[1.1.1.1.2.4.10.4.4.3.2]
b. 14 Dec 1921 d. 9 Mar 1991
+
James T Quackenbush
b. 25 Mar 1922 d. 2 Feb 1999
7
Soloman Sibley
[1.1.1.1.2.4.11]
b. 17 Nov 1769
Sally Stockwell
b. 21 Jan 1774
8
Stephen Sibley
[1.1.1.1.2.4.11.1]
b. 12 Dec 1792
8
Nancy Sibley
[1.1.1.1.2.4.11.2]
b. 19 Jan 1797
+
Nathan Muzzy
b. 24 Dec 1792 d. 23 Jun 1858
8
Heister Sibley
[1.1.1.1.2.4.11.3]
b. 19 Jun 1799
8
Lewis Sibley
[1.1.1.1.2.4.11.4]
b. 8 Jul 1801
8
Stephen Sibley
[1.1.1.1.2.4.11.5]
b. 26 Jul 1805
Charlotte Reed Peirce
b. 7 Jul 1811 d. 22 Aug 1882
9
John Reed Sibley
[1.1.1.1.2.4.11.5.1]
b. 18 Apr 1838
9
George H Sibley
[1.1.1.1.2.4.11.5.2]
b. 17 Aug 1841
+
Emma J Gould
b. 8 Jul 1850
9
Martha P Sibley
[1.1.1.1.2.4.11.5.3]
b. 16 Nov 1843
9
Mary Charlotte Sibley
[1.1.1.1.2.4.11.5.4]
b. 18 May 1847
Albert Marritt Phillips
b. 9 Oct 1843
10
Clara Willis Phillips
[1.1.1.1.2.4.11.5.4.1]
b. 13 May 1884
9
Clara Sophronia Sibley
[1.1.1.1.2.4.11.5.5]
b. 8 Nov 1849
Otis Sumner Pond
b. 3 Nov 1846
10
Arthur N Pond
[1.1.1.1.2.4.11.5.5.1]
b. 1 Mar 1873
+
Mary J
b. Jun 1872
10
Herbert Carroll Pond
[1.1.1.1.2.4.11.5.5.2]
b. 26 May 1877 d. 7 Dec 1930
Mary Jane Leake
b. 1884 d. 23 May 1970
11
Elsie Clara Margaret Pond
[1.1.1.1.2.4.11.5.5.2.1]
b. 21 Nov 1901 d. 6 Sep 1986
11
Adelaide E Pond
[1.1.1.1.2.4.11.5.5.2.2]
b. 1903
8
Solomon Sibley
[1.1.1.1.2.4.11.6]
b. 14 Jun 1808
8
John Sibley
[1.1.1.1.2.4.11.7]
b. 20 Feb 1818 d. 17 Aug 1824
7
Polly Sibley
[1.1.1.1.2.4.12]
b. 4 Dec 1771
Abner C Cummings
b. 9 Oct 1770 d. 1800
8
Nancy Cummings
[1.1.1.1.2.4.12.1]
b. 5 Nov 1795
John Putnam
b. Abt 1792
9
Dulcina Putnam
[1.1.1.1.2.4.12.1.1]
b. 12 Dec 1813 d. 20 Jul 1816
9
Harriet Putnam
[1.1.1.1.2.4.12.1.2]
b. 20 Mar 1815 d. 20 Jul 1816
9
Jane Putnam
[1.1.1.1.2.4.12.1.3]
b. 1 Nov 1816
Walters Putnam
b. 16 Mar 1817
10
Sarah Jane Putnam
[1.1.1.1.2.4.12.1.3.1]
b. 1 Nov 1841
10
Nancy L Putnam
[1.1.1.1.2.4.12.1.3.2]
b. 15 Aug 1845
+
James W Davis
10
Marble Putnam
[1.1.1.1.2.4.12.1.3.3]
b. 19 Aug 1847
Evaline Inez Waters
b. 10 Sep 1850
11
Justin Marble Putnam
[1.1.1.1.2.4.12.1.3.3.1]
b. 27 Feb 1873
+
Blanche May Stone
b. Abt 1875
11
Julia Rosina Putnam
[1.1.1.1.2.4.12.1.3.3.2]
b. 22 Aug 1875 d. Mar 1968
Willis B Robbins
b. Aft 1854 d. 1930
12
Ralph Raymond Robbins
[1.1.1.1.2.4.12.1.3.3.2.1]
b. 29 Feb 1896 d. 28 Jan 1978 [
=>
]
12
Helen May Robbins
[1.1.1.1.2.4.12.1.3.3.2.2]
b. 10 Nov 1897 d. 16 Dec 1982 [
=>
]
12
Child Robbins
[1.1.1.1.2.4.12.1.3.3.2.3]
b. 10 Apr 1901 d. 10 Apr 1900
12
Homer Bates Robbins
[1.1.1.1.2.4.12.1.3.3.2.4]
b. 29 Aug 1905 d. 8 Jun 1937
11
Charles Wesley Putnam
[1.1.1.1.2.4.12.1.3.3.3]
b. 9 Mar 1880
11
Jane Waters Putnam
[1.1.1.1.2.4.12.1.3.3.4]
b. 1 Sep 1882
+
Ezra W Marble
b. Abt 1880
10
Martha Waters Putnam
[1.1.1.1.2.4.12.1.3.4]
b. 3 Nov 1849 d. 8 Feb 1856
10
Henry Waters Putnam
[1.1.1.1.2.4.12.1.3.5]
b. 1 Oct 1855
9
John Perry Putnam
[1.1.1.1.2.4.12.1.4]
b. 27 Mar 1818
9
Ira Putnam
[1.1.1.1.2.4.12.1.5]
b. 15 Nov 1819 d. 12 May 1821
9
Ephraim Laughton Putnam
[1.1.1.1.2.4.12.1.6]
b. 30 Apr 1821 d. 3 Dec 1822
8
Clarissa Cummings
[1.1.1.1.2.4.12.2]
b. 18 Apr 1796 d. 1838
Creenfield Pote Merrill
b. 26 Aug 1794 d. 27 Mar 1876
9
Edward Pote Merrill
[1.1.1.1.2.4.12.2.1]
b. 22 Oct 1820 d. 1870
+
Olive B Lincoln
b. 1823
9
Elizabeth C Merrill
[1.1.1.1.2.4.12.2.2]
b. 26 Feb 1822 d. 16 Dec 1839
9
Greenfield Merrill
[1.1.1.1.2.4.12.2.3]
b. 14 Dec 1825
9
Samuel Merrill
[1.1.1.1.2.4.12.2.4]
b. 28 Oct 1832 d. 1912
9
Creenfield Merrill
[1.1.1.1.2.4.12.2.5]
b. 14 Dec 1834
9
Daniel Cummings Merrill
[1.1.1.1.2.4.12.2.6]
b. 20 Mar 1837 d. 1925
+
Mary A Noyes
b. 23 May 1841 d. 28 Feb 1893
7
Artamus Sibley
[1.1.1.1.2.4.13]
b. 9 Jul 1773 d. 10 Aug 1777
7
Nahum Sibley
[1.1.1.1.2.4.14]
b. 11 Sep 1775 d. 12 Sep 1796
7
Sally Sibley
[1.1.1.1.2.4.15]
b. 6 Jun 1779 d. 21 Mar 1833
Amasa Cummings
b. 17 Jan 1778 d. 22 Mar 1836
8
Abner Cummings
[1.1.1.1.2.4.15.1]
b. 1 Jan 1808
8
Sarah Ann Cummings
[1.1.1.1.2.4.15.2]
b. 22 Oct 1812
8
Nahum Sibley Cummings
[1.1.1.1.2.4.15.3]
b. 7 Jan 1816
+
Hannah Amidon
b. Abt 1730 d. 5 Jun 1822
5
Jonathan Sibley
[1.1.1.1.3]
b. 1 May 1690 d. Abt 1733
Mary Cutler
b. 19 Mar 1691 d. 1734
6
Martha Sibley
[1.1.1.1.3.1]
b. 10 Jul 1731
5
Hannah Sibley
[1.1.1.1.4]
c. 9 May 1695 d. 8 Feb 1731
Ebenezer Daggett
b. 22 Nov 1693 d. 8 Apr 1762
6
Ebenezer Daggett
[1.1.1.1.4.1]
b. 13 Apr 1723 d. Bef 3 Aug 1761
6
Thomas Daggett
[1.1.1.1.4.2]
b. 21 Apr 1725 d. 28 Nov 1758
Martha Stockwell
b. 25 Mar 1724
7
Captain John Daggett
[1.1.1.1.4.2.1]
b. 15 Sep 1748 d. 8 Feb 1816
Mary Stevens
b. 1749
8
Thomas Dagget
[1.1.1.1.4.2.1.1]
b. 5 Aug 1776
Ruth Record
c. 25 Jan 1777
9
Elisha Daggett
[1.1.1.1.4.2.1.1.1]
b. Abt 1801 d. Abt 1881
9
Ruth Daggett
[1.1.1.1.4.2.1.1.2]
b. Abt 1804 d. 1881
9
Thomas Daggett
[1.1.1.1.4.2.1.1.3]
b. Abt 1806
8
John Daggett
[1.1.1.1.4.2.1.2]
b. 14 Oct 1778 d. 6 Jan 1824
Sarah Record
b. 1780 d. 25 Oct 1821
9
Luther Daggett
[1.1.1.1.4.2.1.2.1]
b. 19 Nov 1800
9
Betsey Daggett
[1.1.1.1.4.2.1.2.2]
b. 25 Nov 1802
John Harris
b. 31 Dec 1799
10
Palina Harris
[1.1.1.1.4.2.1.2.2.1]
b. Abt 1831
10
Sarah Harris
[1.1.1.1.4.2.1.2.2.2]
b. Abt 1833
10
Benton Harris
[1.1.1.1.4.2.1.2.2.3]
b. Abt 1834
10
Amelia Harris
[1.1.1.1.4.2.1.2.2.4]
b. Abt 1836
10
Almira Harris
[1.1.1.1.4.2.1.2.2.5]
b. Abt 1839
9
Calvin Daggett
[1.1.1.1.4.2.1.2.3]
b. 24 Jan 1806 d. 1 Jul 1832
Laura Mower
b. 24 May 1805 d. 21 Mar 1863
10
Luther S Daggett
[1.1.1.1.4.2.1.2.3.1]
b. 3 Jan 1826 d. 29 Nov 1873
Almira Larrabee
b. 28 Jan 1825
11
Frank W Daggett
[1.1.1.1.4.2.1.2.3.1.1]
b. 1850
11
Emma J Daggett
[1.1.1.1.4.2.1.2.3.1.2]
b. 1852
11
Ella A Daggett
[1.1.1.1.4.2.1.2.3.1.3]
b. 1860 d. 28 Sep 1873
10
Calvin K Daggett
[1.1.1.1.4.2.1.2.3.2]
b. 22 Feb 1828
+
Rebecca E Cross
b. 1830
10
Henry T Daggett
[1.1.1.1.4.2.1.2.3.3]
b. 13 Feb 1830
10
Luella Jane Daggett
[1.1.1.1.4.2.1.2.3.4]
b. 15 Jul 1832
10
Laura Ann Daggett
[1.1.1.1.4.2.1.2.3.5]
b. 15 Jul 1832 d. 17 Sep 1887
9
Sarah Daggett
[1.1.1.1.4.2.1.2.4]
b. 27 Dec 1809 d. 30 Jun 1832
9
Lucy Daggett
[1.1.1.1.4.2.1.2.5]
b. 15 Aug 1812
9
Anna Daggett
[1.1.1.1.4.2.1.2.6]
b. 26 Nov 1814
9
John Daggett
[1.1.1.1.4.2.1.2.7]
b. 16 Nov 1817
9
Silas Daggett
[1.1.1.1.4.2.1.2.8]
b. 20 Jun 1821
8
Sarah Daggett
[1.1.1.1.4.2.1.3]
b. 2 Apr 1780 d. 1873
Captain Samuel Bates
b. Abt 1776
9
Florentine Bates
[1.1.1.1.4.2.1.3.1]
b. Abt 1802
9
Simeon Bates
[1.1.1.1.4.2.1.3.2]
b. Abt 1804
9
Marilla Bates
[1.1.1.1.4.2.1.3.3]
b. Abt 1806
9
Sarah Bates
[1.1.1.1.4.2.1.3.4]
b. Abt 1808
8
Simeon Daggett
[1.1.1.1.4.2.1.4]
b. Abt 1782
8
Simon Daggett
[1.1.1.1.4.2.1.5]
b. 1786 d. 1807
8
Captain Aaron Daggett
[1.1.1.1.4.2.1.6]
b. 4 Mar 1787 d. 1 Feb 1862
Almira Dearborn
b. 7 May 1789 d. 11 Mar 1830
9
Greenlief Dearborn Quincy Adams Daggett
[1.1.1.1.4.2.1.6.1]
b. 10 Nov 1818 d. 23 Jul 1854
9
Converse Rollin Daggett
[1.1.1.1.4.2.1.6.2]
b. 14 Mar 1820
Anna F Packard Bailey
b. 11 Jun 1845
10
Emma Rose Daggett
[1.1.1.1.4.2.1.6.2.1]
b. 4 Dec 1880
9
Simon Dearborn Alfred Pierce Daggett
[1.1.1.1.4.2.1.6.3]
b. 19 Sep 1822 d. 11 Aug 1840
9
Molly Dearborn Daggett
[1.1.1.1.4.2.1.6.4]
b. 13 Apr 1826 d. 23 Apr 1826
9
Almira Augusta Daggett
[1.1.1.1.4.2.1.6.5]
b. 28 Sep 1827 d. 27 Mar 1865
+
Isaac Cotton Merrill
b. Abt 1823
Dorcas C Dearborn
b. 13 Jun 1796 d. 24 Mar 1869
9
Ebenezer Sanborn Daggett
[1.1.1.1.4.2.1.6.6]
b. 30 Sep 1831
9
John Carroll Daggett
[1.1.1.1.4.2.1.6.7]
b. 29 Jul 1833 d. 12 Dec 1902
Abigail Chandler Fogg
b. 18 Jul 1851 d. 4 Sep 1877
10
Aaron Daggett
[1.1.1.1.4.2.1.6.7.1]
b. 19 Dec 1871
10
Augusta Daggett
[1.1.1.1.4.2.1.6.7.2]
b. 3 Aug 1873
10
Walter Daggett
[1.1.1.1.4.2.1.6.7.3]
b. Jan 1875
9
Mary Daggett
[1.1.1.1.4.2.1.6.8]
b. 9 Jan 1835 d. 1 Oct 1861
9
Brigadier General Aaron Simon Daggett
[1.1.1.1.4.2.1.6.9]
b. 14 Jan 1837 d. 14 May 1931
Martha Rosetta Bradford
b. 11 Sep 1840
10
Mary Augusta Daggett
[1.1.1.1.4.2.1.6.9.1]
b. 21 Oct 1868
10
Royal Bradford Daggett
[1.1.1.1.4.2.1.6.9.2]
b. 13 Nov 1870
10
Alice Southworth Daggett
[1.1.1.1.4.2.1.6.9.3]
b. 11 Aug 1872
10
Helen Daggett
[1.1.1.1.4.2.1.6.9.4]
b. 1 Sep 1881
8
Mary Daggett
[1.1.1.1.4.2.1.7]
b. 5 Jul 1789
Luther Robbins
b. Abt 1785
9
Louisiana Robbins
[1.1.1.1.4.2.1.7.1]
b. Abt 1811
9
Survetus Robbins
[1.1.1.1.4.2.1.7.2]
b. Abt 1813
9
Mary Robbins
[1.1.1.1.4.2.1.7.3]
b. Abt 1815
9
John Robbins
[1.1.1.1.4.2.1.7.4]
b. Abt 1817
9
Clementine Robbins
[1.1.1.1.4.2.1.7.5]
b. Abt 1819
+
Sarah Jones
b. 26 Oct 1749 d. Bef 1775
7
Mary Daggett
[1.1.1.1.4.2.2]
b. 29 Mar 1750 d. Aft 25 Sep 1826
Seth Corbett Jones
b. 21 Mar 1748 d. 14 Apr 1827
8
Samuel Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1]
b. 5 Aug 1773 d. 24 Aug 1846
Matilda Davis
b. 13 Aug 1777 d. Aft 1820
9
Reuben Davis Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.1]
b. 30 Jul 1798 d. 22 Feb 1866
Harriet Dennis Ryan
b. 10 Mar 1799 d. 30 Dec 1891
10
Albert Davis Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.1.1]
b. 29 Jul 1824 d. 5 Sep 1889
Sarah L Frisbie
b. 14 Oct 1837 d. 1 Sep 1914
11
Albert F Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.1.1.1]
b. Oct 1858 d. 8 Dec 1931
10
Sarah Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.1.2]
b. 26 Jun 1826 d. 24 Sep 1827
10
Julia Madeline Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.1.3]
b. 7 Jun 1828 d. 9 Jan 1916
Edward H Sears
b. 14 Dec 1819 d. 16 Jun 1900
11
Caroline Matilda Sears
[1.1.1.1.4.2.2.1.1.3.1]
b. 1 Feb 1854 d. 11 Oct 1854
11
Edward Jones Sears
[1.1.1.1.4.2.2.1.1.3.2]
b. 19 Jun 1858 d. 20 May 1883
+
Charlotte Ethel Louise Hardy
b. Abt 1857 d. 4 Nov 1961
11
Arthur Davis Sears
[1.1.1.1.4.2.2.1.1.3.3]
b. 7 Jan 1861 d. 7 Aug 1861
11
Hattie Cornelia Sears
[1.1.1.1.4.2.2.1.1.3.4]
b. 30 Dec 1862 d. 7 Apr 1863
11
Jennie Madeline Sears
[1.1.1.1.4.2.2.1.1.3.5]
b. 20 Dec 1864 d. 25 Dec 1887
Andrew C Warrick
b. 1860
12
Madeline Warrick
[1.1.1.1.4.2.2.1.1.3.5.1]
b. 1 Sep 1887 d. 22 Jan 1888
11
Julia Louise Sears
[1.1.1.1.4.2.2.1.1.3.6]
b. 22 Sep 1867 d. 24 Jul 1868
11
Maud Elizabeth Sears
[1.1.1.1.4.2.2.1.1.3.7]
b. 14 Aug 1875 d. 15 Feb 1909
Herbert Bridgeman Jones
b. 26 Dec 1867 d. 26 Mar 1961
12
Elaine Sears Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.1.3.7.1]
b. May 1901
12
Martha E Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.1.3.7.2]
b. 1903 d. 15 Apr 1989
10
Henry Orlando Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.1.4]
b. 25 Feb 1831 d. Bef 1870
Cornelia Eliza Frisbie
b. 8 Aug 1833 d. 2 Apr 1899
11
Harry O Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.1.4.1]
b. 16 Oct 1859 d. 24 Oct 1943
Susanne Norton
b. 1877 d. 22 Dec 1962
12
Cornelia F Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.1.4.1.1]
b. 1907
10
Caroline Matilda Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.1.5]
b. 25 Jul 1834 d. 15 Sep 1848
10
Jonathan Edward Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.1.6]
b. 16 Jun 1840 d. 15 Aug 1855
9
Seth Corbitt Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.2]
b. 23 Sep 1800 d. 21 Jul 1867
Isabel Richardson
b. 29 Jun 1801 d. 29 Mar 1885
10
Seth John Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.2.1]
b. 6 Sep 1824 d. 24 Feb 1831
10
William Richardson Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.2.2]
b. 12 Aug 1825 d. 19 Apr 1895
Mary Ann Tryon
b. 1823 d. 5 Jun 1864
11
Child Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.2.2.1]
b. 3 Sep 1847 d. 3 Sep 1847
11
Child Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.2.2.2]
b. 21 Feb 1853 d. 21 Feb 1853
11
Julia L Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.2.2.3]
b. Feb 1854 d. 25 Aug 1862
11
James C Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.2.2.4]
b. Nov 1856 d. 20 Jan 1863
11
Charles C Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.2.2.5]
b. Nov 1858 d. 17 Aug 1862
10
Morris Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.2.3]
b. 12 Mar 1828 d. 2 Feb 1829
10
Henry George Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.2.4]
b. 29 Jun 1830 d. 21 Jan 1888
Francis Mathilda Hayden
b. Aug 1832 d. 15 Aug 1884
11
Seth Corby Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.2.4.1]
b. 1854 d. 3 Aug 1929
11
Francis Henry Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.2.4.2]
b. 1862
11
George Henry Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.2.4.3]
b. 1864
Margaret Kempf
b. 1866
12
Frances Margaret Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.2.4.3.1]
b. 22 Apr 1886
12
Madalyn Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.2.4.3.2]
b. 1890
12
George Henry Jones, Jr
[1.1.1.1.4.2.2.1.2.4.3.3]
b. 1892
12
Seth Corby Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.2.4.3.4]
b. 22 Sep 1896 d. 4 Aug 1956
12
Clarence Alexander Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.2.4.3.5]
b. 1 Sep 1900
10
Hobart Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.2.5]
b. 4 Jun 1832 d. 14 Mar 1887
Isabel Jones
b. 16 Jan 1836 d. 6 Mar 1913
11
Caroline Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.2.5.1]
b. 1857 d. 1870
11
William Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.2.5.2]
b. 1859 d. Bef 1870
11
Alfred Hobart Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.2.5.3]
b. 14 Nov 1862 d. 28 Aug 1922
Edith Baker
b. 24 Jan 1868 d. 23 Nov 1930
12
Josie Edna Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.2.5.3.1]
b. 16 Dec 1894 d. 15 Apr 1895
12
Seth Corbit Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.2.5.3.2]
b. 29 Feb 1896 d. 31 Jul 1956
12
Rueben D Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.2.5.3.3]
b. 25 Sep 1897 d. 10 Jul 1934
12
Margaret Ann Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.2.5.3.4]
b. 11 Aug 1902 d. 4 Nov 1975
12
Theodore Roosevelt Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.2.5.3.5]
b. 19 Oct 1904 d. 11 Dec 1964
12
Cecil Monroe Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.2.5.3.6]
b. 15 Apr 1906 d. 1 May 1969 [
=>
]
12
Hobart S Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.2.5.3.7]
b. 10 Jan 1908 d. 6 Jan 1909
11
Mary E Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.2.5.4]
b. 1867 d. Abt 1897
Rush Carly Kellam
b. 6 Nov 1862 d. 3 Oct 1932
12
Jesse Hobart Kellam
[1.1.1.1.4.2.2.1.2.5.4.1]
b. 26 Feb 1889 d. 25 Jun 1979 [
=>
]
12
Anna Kellam
[1.1.1.1.4.2.2.1.2.5.4.2]
b. 1891
12
Lee Kellam
[1.1.1.1.4.2.2.1.2.5.4.3]
b. 1893
10
Heber C Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.2.6]
b. 24 Dec 1835 d. 17 Apr 1896
Mary Elizabeth Bull
b. 31 Oct 1834
11
Kitty Adeline Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.2.6.1]
b. 4 Nov 1856
+
George W Comstock
b. 11 Aug 1856 d. 29 Apr 1934
11
Mary Ann Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.2.6.2]
b. 15 Apr 1858 d. 28 Jan 1917
Thomas Henry White
b. 25 Nov 1846 d. 26 Feb 1913
12
Joseph Elijah White
[1.1.1.1.4.2.2.1.2.6.2.1]
b. 30 Dec 1875 d. 19 Mar 1950 [
=>
]
12
Emily Ann White
[1.1.1.1.4.2.2.1.2.6.2.2]
b. 13 Jun 1877 d. 17 Oct 1919
12
Mary Elizabeth White
[1.1.1.1.4.2.2.1.2.6.2.3]
b. 28 Mar 1879 d. 18 Aug 1879
12
Pleasant Maud White
[1.1.1.1.4.2.2.1.2.6.2.4]
b. 20 Jun 1880 d. 25 Dec 1932
12
Jacob Jeremiah White
[1.1.1.1.4.2.2.1.2.6.2.5]
b. 14 Oct 1882 d. 6 Jun 1967
12
John Ray White
[1.1.1.1.4.2.2.1.2.6.2.6]
b. 28 Feb 1885 d. 9 Nov 1918
12
Melinda White
[1.1.1.1.4.2.2.1.2.6.2.7]
b. 8 Jul 1887 d. 9 Jun 1920
12
James William White
[1.1.1.1.4.2.2.1.2.6.2.8]
b. 20 Oct 1889 d. 16 Jan 1891
12
Orabella White
[1.1.1.1.4.2.2.1.2.6.2.9]
b. 29 May 1891 d. 30 May 1891
12
Archie Thomas White
[1.1.1.1.4.2.2.1.2.6.2.10]
b. 5 Jan 1897 d. 16 Sep 1966
11
Mary C Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.2.6.3]
b. 10 Jul 1860
10
Mary Elizabeth Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.2.7]
b. 11 Sep 1838 d. 24 Jul 1854
9
Sallie Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.3]
b. 1802
9
Ezra Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.4]
b. 1804 d. 1807
9
Ezra Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.5]
b. 12 Jul 1807 d. 3 Aug 1879
Hannah Maria Jones
b. 1812 d. 2 May 1841
10
John Emory Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.5.1]
b. Feb 1841 d. 30 Dec 1904
Mary Eva Mortimer
b. 7 Oct 1841 d. Aft 1905
11
Francis Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.5.1.1]
b. 6 Jun 1866
11
Agnes Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.5.1.2]
b. 1874
11
Lois Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.5.1.3]
b. Abt 1881
Ann Myatt
b. Abt 1806 d. 12 Mar 1870
10
Mary W Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.5.2]
b. 1844 d. 27 Jun 1917
+
Solomon Wright Davison
b. 1822 d. 21 Oct 1894
+
Catherine Doyle
b. 1843 d. 14 Feb 1886
Lucinda Kingsley
b. 21 Jan 1798 d. 23 Dec 1882
9
Frederick Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.6]
b. 22 Feb 1819 d. 8 Jul 1849
9
William Henry Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.7]
b. 22 Oct 1820 d. 21 Aug 1909
9
Samuel Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.8]
b. 13 Oct 1822 d. 1839
9
Nathaniel Vary Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.9]
b. 13 Oct 1822 d. 15 Feb 1863
Caroline Martin Garr
b. 7 Jul 1836 d. 2 Nov 1912
10
Mark Vary Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.9.1]
b. 3 Jan 1863 d. 1 Mar 1930
Livinia Ann Talbot
b. 10 Nov 1863 d. 2 Sep 1951
11
Nathaniel Vary Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.9.1.1]
b. 24 Jan 1890 d. 15 Mar 1891
11
Clara Lavinia Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.9.1.2]
b. 21 Nov 1891 d. 1 Dec 1968
William Henry Millard
b. 25 Dec 1887 d. 18 Oct 1970
12
Weldon V Millard
[1.1.1.1.4.2.2.1.9.1.2.1]
b. 23 Sep 1915 d. 27 Aug 1931
12
Wayne William Millard
[1.1.1.1.4.2.2.1.9.1.2.2]
b. 23 Sep 1915 d. 10 Oct 1990
12
Anna Irene Millard
[1.1.1.1.4.2.2.1.9.1.2.3]
b. 22 Jun 1919 d. 10 Nov 2005
12
Illa Millard
[1.1.1.1.4.2.2.1.9.1.2.4]
b. 24 Oct 1924 d. 5 Jul 1999
11
Olive Myrl Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.9.1.3]
b. 13 Feb 1894 d. 23 Apr 1948
Raynold Andrew Hansen
b. 25 Mar 1891 d. 30 Nov 1934
12
Ardith Myrl Hansen
[1.1.1.1.4.2.2.1.9.1.3.1]
b. 12 Sep 1920 d. 10 Jan 1998 [
=>
]
12
Raynold Bertran Hansen
[1.1.1.1.4.2.2.1.9.1.3.2]
b. 9 Nov 1922 d. 28 Nov 1993
12
Della Hansen
[1.1.1.1.4.2.2.1.9.1.3.3]
b. 9 Oct 1924 d. 28 Jan 1999 [
=>
]
12
Lila Maurine Hansen
[1.1.1.1.4.2.2.1.9.1.3.4]
b. 12 Jun 1927 d. 30 Dec 1989
12
Carol Dean Hansen
[1.1.1.1.4.2.2.1.9.1.3.5]
b. 3 Nov 1930 d. 24 Jul 1989
11
Henry Alvaro Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.9.1.4]
b. 26 Jul 1896 d. 24 Aug 1928
11
Caroline Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.9.1.5]
b. 20 Dec 1896 d. 27 May 1986
William Don Green
b. 15 Mar 1893 d. 26 Feb 1974
12
Lyle Don Green
[1.1.1.1.4.2.2.1.9.1.5.1]
b. 22 May 1928 d. 9 Jul 1985
12
Gene Rulon Green
[1.1.1.1.4.2.2.1.9.1.5.2]
b. 26 Aug 1930 d. 11 Nov 2006
11
Rhoberta Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.9.1.6]
b. 11 Apr 1901 d. 5 Jan 1990
Orval Grant Bird
b. 20 Apr 1903 d. 7 Aug 1983
12
Livinia Bird
[1.1.1.1.4.2.2.1.9.1.6.1]
b. 7 Oct 1928 d. 15 Dec 1972
12
Enid Ellen Bird
[1.1.1.1.4.2.2.1.9.1.6.2]
b. 30 Nov 1936 d. 11 Aug 1995
11
Mark Alloid Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.9.1.7]
b. 27 Jan 1904 d. 31 May 1968
+
Clara J Gilgen
b. 29 Aug 1907
Mary Louise Willmore
b. 29 Apr 1911 d. 13 Feb 2001
12
Thomas de Rece Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.9.1.7.1]
b. 28 May 1931 d. 20 Mar 2003 [
=>
]
12
Gary Lee Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.9.1.7.2]
b. 5 Jul 1936 d. 15 Dec 2001
11
Lois Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.9.1.8]
b. 14 Dec 1906 d. 14 Dec 1906
9
Calvin Kingsley Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.10]
b. 9 Jul 1824 d. 30 Oct 1915
Polly Baxter
b. 11 Oct 1797 d. 6 Jan 1851
9
Isabel Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.11]
b. 16 Jan 1836 d. 6 Mar 1913
Hobart Jones
b. 4 Jun 1832 d. 14 Mar 1887
10
Caroline Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.11.1]
b. 1857 d. 1870
10
William Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.11.2]
b. 1859 d. Bef 1870
10
Alfred Hobart Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.11.3]
b. 14 Nov 1862 d. 28 Aug 1922
Edith Baker
b. 24 Jan 1868 d. 23 Nov 1930
11
Josie Edna Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.11.3.1]
b. 16 Dec 1894 d. 15 Apr 1895
11
Seth Corbit Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.11.3.2]
b. 29 Feb 1896 d. 31 Jul 1956
+
Fern A Roush
b. 21 Jun 1896 d. 8 Aug 1987
11
Rueben D Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.11.3.3]
b. 25 Sep 1897 d. 10 Jul 1934
11
Margaret Ann Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.11.3.4]
b. 11 Aug 1902 d. 4 Nov 1975
+
Billy Smith
b. 15 Feb 1886 d. 4 Nov 1975
11
Theodore Roosevelt Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.11.3.5]
b. 19 Oct 1904 d. 11 Dec 1964
+
Lucy Rebecca Forker
b. 1902 d. 1940
+
Ethel Marie Trotter
b. 2 Jan 1910 d. 2 Jan 1990
11
Cecil Monroe Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.11.3.6]
b. 15 Apr 1906 d. 1 May 1969
Maude Ellen Cummings
b. 14 Aug 1907 d. 2000
12
Billy Lee Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.11.3.6.1]
b. 17 Apr 1931 d. 1 Mar 1952
12
Barbara Ann Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.11.3.6.2]
b. 17 Apr 1931 d. 2 Feb 2002
11
Hobart S Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.11.3.7]
b. 10 Jan 1908 d. 6 Jan 1909
10
Mary E Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.11.4]
b. 1867 d. Abt 1897
Rush Carly Kellam
b. 6 Nov 1862 d. 3 Oct 1932
11
Jesse Hobart Kellam
[1.1.1.1.4.2.2.1.11.4.1]
b. 26 Feb 1889 d. 25 Jun 1979
Bessie Maria Hill
b. 9 Jan 1888 d. 2 Jul 1970
12
Jesse Hobart Kellam
[1.1.1.1.4.2.2.1.11.4.1.1]
b. 5 Feb 1912 d. 23 Oct 1998
12
Charles R Kellam
[1.1.1.1.4.2.2.1.11.4.1.2]
b. 27 Jun 1918 d. 6 Nov 1996
12
Russell Lee Kellam
[1.1.1.1.4.2.2.1.11.4.1.3]
b. 8 May 1924 d. 10 Dec 1992
11
Anna Kellam
[1.1.1.1.4.2.2.1.11.4.2]
b. 1891
11
Lee Kellam
[1.1.1.1.4.2.2.1.11.4.3]
b. 1893
9
Harriet Jones
[1.1.1.1.4.2.2.1.12]
b. 2 Apr 1838 d. Aft 1855
8
Aaron Jones
[1.1.1.1.4.2.2.2]
b. 23 Mar 1775
8
Sarah Jones
[1.1.1.1.4.2.2.3]
b. 23 Sep 1777 d. 17 May 1838
Joel Pratt
b. Abt 1776 d. 18 May 1866
9
Reuben Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.1]
b. 13 Nov 1803 d. 31 May 1861
Mary T
10
Joel F Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.1.1]
b. 27 Sep 1830 d. 1919
Ellen M Doubleday
b. 2 Apr 1835 d. 1913
11
Lizzie E Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.1.1.1]
b. 12 Jun 1869
11
Fannie A Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.1.1.2]
b. 16 Feb 1873
10
Mary Esther Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.1.2]
b. 22 Aug 1834
+
Elbridge H Eames
b. 1825
10
Sarah J Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.1.3]
b. 1837
10
Jacob Elbridge Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.1.4]
b. 12 Dec 1838
10
Nelson Reuben Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.1.5]
b. Abt 1841 d. 31 Mar 1895
Anna Lostin Withee
b. Abt 1844 d. 24 Jan 1905
11
Eva Leah Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.1.5.1]
b. Dec 1863
Walter Herbert Burgess
b. 11 Jan 1867 d. 1 Jul 1964
12
Herbert Burgess
[1.1.1.1.4.2.2.3.1.5.1.1]
b. Nov 1890 d. 1910
12
Lizzie Maude Burgess
[1.1.1.1.4.2.2.3.1.5.1.2]
b. 31 May 1893 d. 2 Sep 1973
12
Carroll Burgess
[1.1.1.1.4.2.2.3.1.5.1.3]
b. 10 Mar 1895 d. 26 Jan 1982
12
Myra S Burgess
[1.1.1.1.4.2.2.3.1.5.1.4]
b. 30 Sep 1900 d. 2 Jan 1987
12
Hugh F Burgess
[1.1.1.1.4.2.2.3.1.5.1.5]
b. 1 Oct 1902 d. 9 Aug 1980
12
Laurice E Burgess
[1.1.1.1.4.2.2.3.1.5.1.6]
b. 21 Jul 1905 d. 16 Oct 1976
12
Thelma M Burgess
[1.1.1.1.4.2.2.3.1.5.1.7]
b. 9 Mar 1907 d. 18 Feb 1985
11
Samuel T Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.1.5.2]
b. 1867
Mrs Pratt
12
Eva L Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.1.5.2.1]
b. May 1894
11
Lizzie M Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.1.5.3]
b. 13 Mar 1875 d. 24 Jun 1889
10
Marilla Sarah Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.1.6]
b. 1844
Olive Fitzgerald
b. 13 Jun 1816
10
Henrietta F. Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.1.7]
b. 1850 d. 19 Feb 1934
9
Nelson Chapin Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.2]
b. 18 Jul 1805 d. 14 Mar 1864
Artemesia Hammond
b. 5 May 1809
10
Sarah Jones Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.2.1]
b. 13 May 1828 d. 14 Dec 1862
Daniel Webster Smith
b. 18 Apr 1826 d. 16 Dec 1888
11
Clara Luella Smith
[1.1.1.1.4.2.2.3.2.1.1]
b. 26 Mar 1849
11
Isaac Smith
[1.1.1.1.4.2.2.3.2.1.2]
b. 9 Dec 1850 d. 19 Mar 1918
Margaret Alice White
b. 13 Jul 1857 d. 28 Dec 1929
12
Helen Wirt Smith
[1.1.1.1.4.2.2.3.2.1.2.1]
b. 21 Sep 1880 [
=>
]
12
Emma Rebbeca Smith
[1.1.1.1.4.2.2.3.2.1.2.2]
b. 27 Oct 1884 d. 8 Nov 1956 [
=>
]
12
Elizabeth Cotton Smith
[1.1.1.1.4.2.2.3.2.1.2.3]
b. 16 Apr 1887 d. 8 Oct 1893
12
Frank L Smith
[1.1.1.1.4.2.2.3.2.1.2.4]
b. 16 May 1892 d. 23 Nov 1938 [
=>
]
11
Daniel Webster Smith
[1.1.1.1.4.2.2.3.2.1.3]
b. 16 Feb 1853 d. 18 Jan 1918
11
Edward Crawford Smith
[1.1.1.1.4.2.2.3.2.1.4]
b. 24 Aug 1855 d. 16 Jun 1864
11
Elizabeth Smith
[1.1.1.1.4.2.2.3.2.1.5]
b. 15 Nov 1857 d. 8 Oct 1893
Harris Mose Combs
b. Oct 1847 d. 1921
12
Robert Combs
[1.1.1.1.4.2.2.3.2.1.5.1]
b. Dec 1876
12
Lorenzo L Combs
[1.1.1.1.4.2.2.3.2.1.5.2]
b. Sep 1878
12
Mary Combs
[1.1.1.1.4.2.2.3.2.1.5.3]
b. 21 Aug 1881 d. 21 Aug 1882
12
Clara Combs
[1.1.1.1.4.2.2.3.2.1.5.4]
b. 9 Dec 1883
11
Charles Hammond Smith
[1.1.1.1.4.2.2.3.2.1.6]
b. 9 Apr 1860
10
Martha Baker Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.2.2]
b. 7 Nov 1830
10
Maria Hammond Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.2.3]
b. Abt 1834 d. 28 Dec 1863
10
Artimisha Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.2.4]
b. Abt 1835
Julia Abbie Gowen
b. Abt 1818 d. 9 Oct 1886
10
George Oscar Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.2.5]
b. 4 Apr 1845 d. 1 May 1929
Alice E Taylor
b. 5 May 1849 d. 4 Dec 1926
11
Albert Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.2.5.1]
b. 1869
11
Fred Elmer Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.2.5.2]
b. 25 Apr 1872 d. 26 Aug 1949
+
Margaret Abigale Kelly
b. Abt 1886
11
Ivy Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.2.5.3]
b. Abt 1874
+
Cassius M Bellows
b. Jul 1859 d. 29 Nov 1909
11
William Andrus Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.2.5.4]
b. 27 Jan 1879
11
Charles Francis Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.2.5.5]
b. Abt 1882
11
George Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.2.5.6]
b. Abt 1885
11
Robert Fulton Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.2.5.7]
b. 30 Jun 1887
+
Annie Eliza Crook
b. 30 Oct 1886 d. 18 Apr 1985
10
Francis A Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.2.6]
b. Apr 1847 d. 1945
Mary Elizabeth Libby
b. Abt 1847 d. 1934
11
Isa R Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.2.6.1]
b. May 1870 d. 1960
11
Anna B Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.2.6.2]
b. May 1872
11
Sadie M Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.2.6.3]
b. Abt 1875
11
Bertha E Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.2.6.4]
b. 21 May 1879
11
Frank Adelbert Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.2.6.5]
b. 21 May 1879 d. 15 Jul 1966
+
Laura M
b. Abt 1878
11
Luella L Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.2.6.6]
b. Mar 1881
11
Ruth Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.2.6.7]
b. 1883
10
William A Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.2.7]
b. Abt 1850
10
Nelson Chapman Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.2.8]
b. 31 Oct 1851 d. 1912
Sarah Narcissa McFarland
b. 31 Oct 1867 d. 1936
11
Pearl Auntie Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.2.8.1]
b. Dec 1889
+
Francis James Conway
b. 29 Nov 1886 d. 8 Feb 1937
11
Mayme Gertrude Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.2.8.2]
b. 8 Nov 1896 d. 24 Dec 1983
Paul Livingston Conway
b. 29 Aug 1892 d. 3 Mar 1972
12
Frances Livingston Conway
[1.1.1.1.4.2.2.3.2.8.2.1]
b. 3 Jun 1919 d. May 1978
12
Betty Sue Conway
[1.1.1.1.4.2.2.3.2.8.2.2]
b. 1 Aug 1926 d. 24 Dec 1985
10
Lillie Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.2.9]
b. Abt 1854
9
Seth Corbett Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.3]
b. 2 Sep 1807 d. 2 Jun 1880
Mary Herring
b. 2 Feb 1813 d. 22 Nov 1895
10
Cyntha B Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.3.1]
b. 21 Mar 1835 d. 28 May 1928
George Dana Boardman Herring
b. 25 Feb 1834 d. 17 Dec 1898
11
Fred Herbert Herring
[1.1.1.1.4.2.2.3.3.1.1]
b. 31 Mar 1858 d. 1 Aug 1919
11
Charles Henry Herring
[1.1.1.1.4.2.2.3.3.1.2]
b. 24 Jul 1859 d. 10 Jan 1862
11
John H. Herring
[1.1.1.1.4.2.2.3.3.1.3]
b. 5 Jul 1861 d. 3 Apr 1862
11
Freeland W Herring
[1.1.1.1.4.2.2.3.3.1.4]
b. 3 Jun 1868 d. 1948
10
Henry Otis Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.3.2]
b. 11 Feb 1838 d. 22 May 1901
Hala Woodard
b. 18 Apr 1844 d. 9 Apr 1931
11
Myrtilia Hala Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.3.2.1]
b. 20 Sep 1866
11
Gertrude Emma Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.3.2.2]
b. 29 May 1868
+
William Franklin Kilborn
d. 11 Oct 1919
11
George H Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.3.2.3]
b. 22 Mar 1871 d. 23 Oct 1893
11
Henry Otis Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.3.2.4]
b. 26 Jul 1872 d. 28 Feb 1903
11
Ralph Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.3.2.5]
b. 2 Jun 1875 d. 3 Apr 1899
11
Ruth Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.3.2.6]
b. 6 May 1883
+
Andrew Ivery Keener
10
George William Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.3.3]
b. 13 Aug 1840 d. 18 Apr 1910
+
Elmira Frances Stickney
b. 18 May 1841
Margaret Yeoman
b. 18 Mar 1865
11
Lillian Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.3.3.1]
b. 1888 d. 1889
11
George Henry Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.3.3.2]
b. 4 Jan 1895
10
Emilie H Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.3.4]
b. 16 Dec 1849
+
Henry B Stanhope
b. 5 Jan 1844
9
Lawson Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.4]
b. 13 Sep 1810
Caroline
b. 1814
10
Eugene Abba Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.4.1]
b. 14 Jul 1837
9
Esther Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.5]
b. 12 Dec 1812
Daniel Mansfield
b. 20 Dec 1808
10
Joseph D Mansfield
[1.1.1.1.4.2.2.3.5.1]
b. 1842
10
Stacy Tucker Mansfield
[1.1.1.1.4.2.2.3.5.2]
b. 19 May 1845
Mary Ellen Loud
b. 14 Mar 1854
11
Ethel Mary Mansfield
[1.1.1.1.4.2.2.3.5.2.1]
b. 10 Jun 1877 d. 1972
+
George Lewis Burrill
b. 19 Mar 1857 d. 31 Aug 1932
11
Avis Loud Mansfield
[1.1.1.1.4.2.2.3.5.2.2]
b. 10 Apr 1880
10
Julia L Mansfield
[1.1.1.1.4.2.2.3.5.3]
b. 1846 d. 20 Apr 1894
+
Benjamin Franklin Pratt
b. 18 Jan 1839 d. 16 Jul 1912
10
Seth C P Mansfield
[1.1.1.1.4.2.2.3.5.4]
b. 1848
10
Sarah A Mansfield
[1.1.1.1.4.2.2.3.5.5]
b. 1850
10
Wooster P Mansfield
[1.1.1.1.4.2.2.3.5.6]
b. 1852
Maria J Bolton
b. Jul 1850
11
Bertha Eliza Mansfield
[1.1.1.1.4.2.2.3.5.6.1]
b. 27 Jun 1882
10
Charles O Mansfield
[1.1.1.1.4.2.2.3.5.7]
b. 1855
9
Marilla May Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.6]
b. 3 Sep 1814 d. 4 Mar 1835
9
Joel Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.7]
b. 3 Sep 1817 d. 1822
9
Sarah Jane Pratt
[1.1.1.1.4.2.2.3.8]
b. 30 Aug 1819 d. 12 May 1838
8
Mary Jones
[1.1.1.1.4.2.2.4]
b. 9 Dec 1780 d. 30 Oct 1831
John Bigelow
b. 12 Aug 1787 d. 6 Sep 1808
9
Mary Dagget Bigelow
[1.1.1.1.4.2.2.4.1]
b. 4 Apr 1807 d. 6 Mar 1873
Varnum Brigham
b. 8 Jul 1802 d. 25 Jul 1848
10
Persis Penelope Brigham
[1.1.1.1.4.2.2.4.1.1]
b. 1 Aug 1825 d. 4 Jan 1851
10
Mary Jones Brigham
[1.1.1.1.4.2.2.4.1.2]
b. 14 Jun 1827 d. 25 Sep 1827
10
Calvin L Brigham
[1.1.1.1.4.2.2.4.1.3]
b. 8 Sep 1828 d. 15 Oct 1850
10
Sarah J Brigham
[1.1.1.1.4.2.2.4.1.4]
b. 23 Sep 1830 d. 23 Jan 1856
+
William Eager
b. Abt 1826 d. Abt 1886
10
Varnum Bigelow Brigham
[1.1.1.1.4.2.2.4.1.5]
b. 21 Feb 1833 d. Abt 1893
Cate Harris
b. Abt 1837 d. Abt 1897
11
Varnum Charles Brigham
[1.1.1.1.4.2.2.4.1.5.1]
b. Abt 1859
10
Emery P Brigham
[1.1.1.1.4.2.2.4.1.6]
b. 18 Jan 1835 d. Jan 1835
10
Mary Lucy Brigham
[1.1.1.1.4.2.2.4.1.7]
b. 18 May 1836 d. 1872
John H Robinson
b. 1832 d. Abt 1892
11
Willie H Robinson
[1.1.1.1.4.2.2.4.1.7.1]
b. Abt 1858
10
Frances Felicia Brigham
[1.1.1.1.4.2.2.4.1.8]
b. 3 Sep 1838 d. 24 May 1900
Nathaniel Fenner Hopkins
b. 4 Feb 1838 d. Abt 1898
11
Clarence B Hopkins
[1.1.1.1.4.2.2.4.1.8.1]
b. 4 Jul 1862
11
Martha Amelia Hopkins
[1.1.1.1.4.2.2.4.1.8.2]
b. 18 Feb 1865
11
Maude Frances Hopkins
[1.1.1.1.4.2.2.4.1.8.3]
b. 30 Mar 1867
11
Florence Evelyn Hopkins
[1.1.1.1.4.2.2.4.1.8.4]
b. 1 Oct 1868
11
Stella Hopkins
[1.1.1.1.4.2.2.4.1.8.5]
b. 17 Jun 1870
10
Martha A Brigham
[1.1.1.1.4.2.2.4.1.9]
b. 25 Jul 1840 d. 1864
+
George Shattuck
b. 1836 d. Abt 1896
10
John A Brigham
[1.1.1.1.4.2.2.4.1.10]
b. 18 Sep 1843 d. 2 Aug 1854
10
Abby H Brigham
[1.1.1.1.4.2.2.4.1.11]
b. 31 Dec 1845 d. Abt 1905
Horace M Emerson
b. 7 Nov 1840 d. 1881
11
Mary D Emerson
[1.1.1.1.4.2.2.4.1.11.1]
b. 1866
+
Walter E Dyer
b. Abt 1862
11
Oliver Emerson
[1.1.1.1.4.2.2.4.1.11.2]
b. 1869
9
John Jones Bigelow
[1.1.1.1.4.2.2.4.2]
b. 31 Jan 1809 d. 2 Jun 1848
Susan McKinstry
b. 1 Jun 1816 d. 8 Nov 1891
10
John Karresty Bigelow
[1.1.1.1.4.2.2.4.2.1]
b. 7 Aug 1836 d. 21 Aug 1836
10
Andrew Laroy Bigelow
[1.1.1.1.4.2.2.4.2.2]
b. 16 Aug 1840
Mary Theresa Higgins
b. 22 May 1846
11
Justin Osbert Bigelow
[1.1.1.1.4.2.2.4.2.2.1]
b. 6 Jul 1868
11
Mary Elizabeth Bigelow
[1.1.1.1.4.2.2.4.2.2.2]
b. 9 Aug 1869
11
Harry Laroy Bigelow
[1.1.1.1.4.2.2.4.2.2.3]
b. 7 Nov 1870
8
Lydia Jones
[1.1.1.1.4.2.2.5]
b. 15 Oct 1783
8
Seth Corbett Jones, Jr
[1.1.1.1.4.2.2.6]
b. 16 Oct 1785 d. 27 May 1807
8
Altheda Jones
[1.1.1.1.4.2.2.7]
b. 27 Oct 1787 d. 28 Mar 1790
8
Cynthia Jones
[1.1.1.1.4.2.2.8]
b. 13 May 1791 d. 5 Jan 1827
8
Rachel Jones
[1.1.1.1.4.2.2.9]
b. 23 Apr 1793 d. 3 May 1823
7
David Daggett
[1.1.1.1.4.2.3]
b. 27 Jun 1751 d. 14 May 1777
Bulah Johnson
b. 1750
8
Azubah Dagget
[1.1.1.1.4.2.3.1]
b. 15 Mar 1774
Daniel Town
b. 1774
9
Betsy Town
[1.1.1.1.4.2.3.1.1]
b. 1795 d. 13 Feb 1890
Abegence Weld
b. 12 Mar 1795 d. 5 Nov 1848
10
William Weld
[1.1.1.1.4.2.3.1.1.1]
b. 1817
Sarah E Weld
b. 1820
11
Frank Russell Weld
[1.1.1.1.4.2.3.1.1.1.1]
b. 24 May 1854
+
Edith May Parker
b. 1858
10
Damon Weld
[1.1.1.1.4.2.3.1.1.2]
b. 1820 d. 6 Jun 1847
10
Deborah Weld
[1.1.1.1.4.2.3.1.1.3]
b. 1822
10
Russell Weld
[1.1.1.1.4.2.3.1.1.4]
b. 18 Jun 1824 d. 5 May 1904
+
Content H Porter
b. 1828 d. 5 May 1904
10
Philena Weld
[1.1.1.1.4.2.3.1.1.5]
b. 1828 d. 9 Jun 1898
Thomas Miles Dwelly
b. 12 Jul 1822 d. 21 Jan 1885
11
Lena Dwelly
[1.1.1.1.4.2.3.1.1.5.1]
b. 30 Jun 1878
+
Frank Russell
b. 1875
10
Adaline Elizabeth Weld
[1.1.1.1.4.2.3.1.1.6]
b. Abt 1833 d. 2 Jan 1914
David Clinton Bradway
b. 14 Nov 1831 d. 20 Oct 1914
11
Abby Josephine Bradway
[1.1.1.1.4.2.3.1.1.6.1]
b. 18 Nov 1855 d. 5 Jan 1856
11
Herbert Clinton Bradway
[1.1.1.1.4.2.3.1.1.6.2]
b. 5 May 1857 d. 19 Aug 1937
Elmina Hardin Brown
b. 25 Dec 1855 d. 15 Sep 1928
12
Bessie Adaline Bradway
[1.1.1.1.4.2.3.1.1.6.2.1]
b. 25 May 1882 d. 5 Jan 1961 [
=>
]
12
Olney Bradway
[1.1.1.1.4.2.3.1.1.6.2.2]
b. 31 Oct 1887 d. 3 Nov 1887
12
Ruby Mae Bradway
[1.1.1.1.4.2.3.1.1.6.2.3]
b. 19 Jul 1889 d. 6 Dec 1965 [
=>
]
12
Nettie Lavina Bradway
[1.1.1.1.4.2.3.1.1.6.2.4]
b. 31 Jan 1893 d. 26 Jan 1987 [
=>
]
12
Russell Weld Bradway
[1.1.1.1.4.2.3.1.1.6.2.5]
b. 8 Nov 1895 d. 15 Aug 1976
12
Dorothy Caroline Bradway
[1.1.1.1.4.2.3.1.1.6.2.6]
b. 8 Jan 1898 d. 13 Jul 1961 [
=>
]
11
William Weld Bradway
[1.1.1.1.4.2.3.1.1.6.3]
b. 14 Mar 1863 d. 5 Feb 1936
Nora Faskett
b. 22 Nov 1866 d. 12 Jul 1906
12
Andrew Clinton Bradway
[1.1.1.1.4.2.3.1.1.6.3.1]
b. 4 Apr 1887 d. 24 Mar 1960 [
=>
]
12
Mary S Bradway
[1.1.1.1.4.2.3.1.1.6.3.2]
b. 31 Jan 1889 d. 23 May 1972
12
Floa Bradway
[1.1.1.1.4.2.3.1.1.6.3.3]
b. 30 Dec 1894 d. 10 Feb 1895
12
Herbert Foskett Bradway
[1.1.1.1.4.2.3.1.1.6.3.4]
b. 14 May 1897 d. 1961 [
=>
]
11
Bessie Bradway
[1.1.1.1.4.2.3.1.1.6.4]
b. 1865 d. 1866
10
Daniel Weld
[1.1.1.1.4.2.3.1.1.7]
b. 1834 d. 9 Dec 1899
Eliza Holmes
b. Sep 1839 d. 1 Apr 1921
11
Etta L Weld
[1.1.1.1.4.2.3.1.1.7.1]
b. Jan 1859 d. 31 Oct 1936
Jerry Mann
b. 1857
12
Albert J Mann
[1.1.1.1.4.2.3.1.1.7.1.1]
b. 9 Feb 1879 d. 1900
12
Charles A Mann
[1.1.1.1.4.2.3.1.1.7.1.2]
b. Feb 1881 d. 22 Jan 1934
12
Eddie Mann
[1.1.1.1.4.2.3.1.1.7.1.3]
b. 18 Jun 1882
11
Cora Bell Weld
[1.1.1.1.4.2.3.1.1.7.2]
b. 1867 d. 21 Aug 1867
11
Bessie Weld
[1.1.1.1.4.2.3.1.1.7.3]
b. Jul 1869 d. 9 Dec 1954
+
Fred A Eastman
b. Abt 1874
Azubah Wheelock
b. 15 Jan 1745 d. 8 Feb 1804
8
Lyman Daggett
[1.1.1.1.4.2.3.2]
b. 22 Aug 1775 d. 30 Apr 1870
Sarah West Hathaway
b. 22 Feb 1785
9
Catherine H Daggett
[1.1.1.1.4.2.3.2.1]
b. 27 Aug 1807 d. 19 Jan 1890
Loam Hathaway
b. 15 Sep 1803 d. 26 Sep 1883
10
Edwin Augustus Hathaway
[1.1.1.1.4.2.3.2.1.1]
b. 1 Feb 1831 d. 29 Mar 1835
10
Martin Van Buren Hathaway
[1.1.1.1.4.2.3.2.1.2]
b. 21 Sep 1837 d. 3 Jan 1894
+
Eliza Marie Noyes
b. 28 Jul 1854 d. 12 Jan 1936
10
Fernando Cortez Hathaway
[1.1.1.1.4.2.3.2.1.3]
b. 29 Aug 1844 d. 6 Jul 1873
Hattie Z Woodbury
b. 22 Jun 1846
11
Son Hathaway
[1.1.1.1.4.2.3.2.1.3.1]
b. 31 Jul 1870
11
Alice Corey Hathaway
[1.1.1.1.4.2.3.2.1.3.2]
b. 18 Apr 1873
10
Lyman Daggett Hathaway
[1.1.1.1.4.2.3.2.1.4]
b. 29 Aug 1833 d. 27 May 1890
Selina E Drew
b. 8 Aug 1834
11
Ina Estella Hathaway
[1.1.1.1.4.2.3.2.1.4.1]
b. 3 Feb 1877
9
Clarissa Amanda Daggett
[1.1.1.1.4.2.3.2.2]
b. 22 Oct 1810 d. 7 Jan 1879
Chester Bugbee
b. 21 Sep 1808 d. 22 May 1875
10
Walter S Bugbee
[1.1.1.1.4.2.3.2.2.1]
b. 20 Mar 1818 d. 1 Apr 1825
10
Sarah West Bugbee
[1.1.1.1.4.2.3.2.2.2]
b. 4 Jan 1835
+
George S Gray
b. 16 Jan 1834
10
Willard Chester Bugbee
[1.1.1.1.4.2.3.2.2.3]
b. 19 Jul 1836 d. 11 Jun 1918
Laura Amanda Hammond
b. 4 Nov 1842 d. 18 Jan 1864
11
Mary A Bugbee
[1.1.1.1.4.2.3.2.2.3.1]
b. 4 Apr 1861 d. 25 Dec 1863
11
Minnie G Bugbee
[1.1.1.1.4.2.3.2.2.3.2]
b. 17 May 1863
Fred J Robbins
b. 1859
12
James Clarence Robbins
[1.1.1.1.4.2.3.2.2.3.2.1]
b. 23 Jul 1888 d. 16 Apr 1973 [
=>
]
12
Willard Buzzell Robbins
[1.1.1.1.4.2.3.2.2.3.2.2]
b. 31 Jan 1892 d. 1957
Emma A Paine
b. 25 Oct 1845
11
Chester Willard Bugbee
[1.1.1.1.4.2.3.2.2.3.3]
b. 3 Aug 1870 d. 1920
Mary Anna Huntoon
b. 13 Sep 1875 d. 1920
12
Willard Bugbee
[1.1.1.1.4.2.3.2.2.3.3.1]
b. Jan 1899
11
Katie Stevens Bugbee
[1.1.1.1.4.2.3.2.2.3.4]
b. 2 Jul 1871
George Alfred Wheelock
b. 26 Jul 1871
12
Julia Katherine Wheelock
[1.1.1.1.4.2.3.2.2.3.4.1]
b. 28 May 1901
11
Angie E Bugbee
[1.1.1.1.4.2.3.2.2.3.5]
b. 9 Nov 1878 d. 12 Apr 1896
11
Frank A Bugbee
[1.1.1.1.4.2.3.2.2.3.6]
b. 8 Apr 1885
+
Lillian B Shepard
b. 26 Mar 1887 d. 2 Dec 1963
10
Julia Amanda Bugbee
[1.1.1.1.4.2.3.2.2.4]
b. 19 Aug 1838 d. 9 Aug 1863
+
Edward Morris Hamblett
b. 13 Mar 1829 d. 12 Apr 1893
10
Catherine Reliance Bugbee
[1.1.1.1.4.2.3.2.2.5]
b. 11 Feb 1841
Clark M Gray
b. 27 Jun 1842
11
Daughter Gray
[1.1.1.1.4.2.3.2.2.5.1]
b. 19 Jul 1872
10
Maria E Bugbee
[1.1.1.1.4.2.3.2.2.6]
b. 6 Apr 1843
Elias Benjamin Wakefield
b. 29 Jan 1844
11
Anna M Wakefield
[1.1.1.1.4.2.3.2.2.6.1]
b. 17 Nov 1868
11
Mary Alice Wakefield
[1.1.1.1.4.2.3.2.2.6.2]
b. 20 Feb 1871
11
Charles Elmore Wakefield
[1.1.1.1.4.2.3.2.2.6.3]
b. 13 Dec 1882
10
William Wallace Bugbee
[1.1.1.1.4.2.3.2.2.7]
b. 5 Apr 1845 d. 22 Aug 1846
10
Walter S Bugbee
[1.1.1.1.4.2.3.2.2.8]
b. 3 Mar 1848 d. 7 Jul 1863
10
Emma Arvilla Bugbee
[1.1.1.1.4.2.3.2.2.9]
b. 19 Jan 1849 d. 25 May 1881
Edward Morris Hamblett
b. 13 Mar 1829 d. 12 Apr 1893
11
Della Julia Hamblet
[1.1.1.1.4.2.3.2.2.9.1]
b. 25 Mar 1863 d. 1 Oct 1916
Solomon Jacobs Cameron
b. 8 May 1859 d. 24 Mar 1897
12
Clarence Kimball Cameron
[1.1.1.1.4.2.3.2.2.9.1.1]
b. 2 Nov 1882 d. 29 Aug 1952
11
Lunn Lorenzo Hamblett
[1.1.1.1.4.2.3.2.2.9.2]
b. 25 Feb 1876 d. 26 Mar 1959
Stella Maude Blaisdell
b. 6 Feb 1881 d. 21 Oct 1970
12
Maurice Franklin Hamblett
[1.1.1.1.4.2.3.2.2.9.2.1]
b. 24 Feb 1918 d. 25 Jan 2011
12
Fern Shepherd Hamblett
[1.1.1.1.4.2.3.2.2.9.2.2]
b. 1 Apr 1919 d. Apr 1992
9
Pardon Daggett
[1.1.1.1.4.2.3.2.3]
b. 14 Feb 1818 d. 1 Apr 1825
8
David Daggett
[1.1.1.1.4.2.3.3]
b. 31 Jan 1776 d. 28 Sep 1861
Hannah Moffett
b. 7 Jan 1776 d. 31 Jan 1810
9
Sally Learned Daggett
[1.1.1.1.4.2.3.3.1]
b. 13 Apr 1799 d. Bef 1834
+
Thomas Pray
b. 1801 d. 12 Jan 1876
9
Azubah Daggett
[1.1.1.1.4.2.3.3.2]
b. 8 Mar 1802 d. 3 May 1881
Jonathan Danforth
b. 11 May 1798 d. 23 Feb 1859
10
Philora A Danforth
[1.1.1.1.4.2.3.3.2.1]
b. 1828 d. 15 Mar 1857
10
Augusta Danforth
[1.1.1.1.4.2.3.3.2.2]
b. 1831 d. Aft 1850
10
Cynthia Danforth
[1.1.1.1.4.2.3.3.2.3]
b. 1833 d. Aft 1850
10
Emily J Danforth
[1.1.1.1.4.2.3.3.2.4]
b. 1834 d. 21 Aug 1853
10
Chancy B Danforth
[1.1.1.1.4.2.3.3.2.5]
b. 1835 d. 19 May 1860
10
Helen M Danforth
[1.1.1.1.4.2.3.3.2.6]
b. 1837 d. 17 Jan 1861
10
Sarah Jane Danforth
[1.1.1.1.4.2.3.3.2.7]
b. 1839 d. Aft 1850
10
Harriet N Danforth
[1.1.1.1.4.2.3.3.2.8]
b. 1842 d. 5 May 1862
9
Erasmus Daggett
[1.1.1.1.4.2.3.3.3]
b. 13 Mar 1804
9
Asahel Daggett
[1.1.1.1.4.2.3.3.4]
b. 15 Feb 1807 d. 13 Mar 1890
Eliza White
b. 15 Sep 1810 d. Mar 1861
10
Delia Ann Daggett
[1.1.1.1.4.2.3.3.4.1]
b. May 1830 d. May 1861
10
William Penn Daggett
[1.1.1.1.4.2.3.3.4.2]
b. 1834
Elizabeth "Betsey" Shepherd
b. 9 Sep 1838 d. 30 May 1928
11
John Welsley Daggett
[1.1.1.1.4.2.3.3.4.2.1]
b. Jun 1858
Anna Josephine Schwind
b. 7 Nov 1860 d. 8 Sep 1938
12
Elizabeth Jane Daggett
[1.1.1.1.4.2.3.3.4.2.1.1]
b. 28 Aug 1884 d. 1932 [
=>
]
12
Bessie Daggett
[1.1.1.1.4.2.3.3.4.2.1.2]
b. Oct 1885
12
Mabel C Daggett
[1.1.1.1.4.2.3.3.4.2.1.3]
b. 11 Nov 1886 d. 19 Mar 1981 [
=>
]
12
Henry Daggett
[1.1.1.1.4.2.3.3.4.2.1.4]
b. Jan 1889
12
Clarence Daggett
[1.1.1.1.4.2.3.3.4.2.1.5]
b. Mar 1891
12
Stella Daggett
[1.1.1.1.4.2.3.3.4.2.1.6]
b. May 1893
10
Caroline Daggett
[1.1.1.1.4.2.3.3.4.3]
b. 1849
Henry Sanford Gideon
b. 1 Sep 1836 d. 28 Dec 1902
11
Jene Gideon
[1.1.1.1.4.2.3.3.4.3.1]
b. 1862
11
John Gideon
[1.1.1.1.4.2.3.3.4.3.2]
b. 1869
11
Edith Gideon
[1.1.1.1.4.2.3.3.4.3.3]
b. 1871
11
Elizabeth Gideon
[1.1.1.1.4.2.3.3.4.3.4]
b. 1873
11
William Henry Gideon
[1.1.1.1.4.2.3.3.4.3.5]
b. 10 Feb 1877 d. 22 Jul 1943
Grace Darling
b. 10 Sep 1880 d. 2 Apr 1955
12
Garnet Irene Gideon
[1.1.1.1.4.2.3.3.4.3.5.1]
b. 30 Jun 1901 d. 20 Dec 1916
12
Iona Darling Gideon
[1.1.1.1.4.2.3.3.4.3.5.2]
b. 23 Aug 1904 d. 12 Mar 1970 [
=>
]
11
Ada M Gideon
[1.1.1.1.4.2.3.3.4.3.6]
b. 1879
11
Zea Asheal Gideon
[1.1.1.1.4.2.3.3.4.3.7]
b. 20 Sep 1881
Bertha Eveline Couey
b. 10 Jul 1881 d. 7 Jun 1961
12
Edith Gertrude Gideon
[1.1.1.1.4.2.3.3.4.3.7.1]
b. 29 Apr 1903 d. 17 Jun 1975
12
Genevieve Couey Gideon
[1.1.1.1.4.2.3.3.4.3.7.2]
b. 1 Dec 1905 d. 31 Jul 1958
12
Son Gideon
[1.1.1.1.4.2.3.3.4.3.7.3]
b. 1906 d. 1906
12
Norman Atlas Gideon
[1.1.1.1.4.2.3.3.4.3.7.4]
b. 4 Oct 1909 d. 21 May 1984
12
Bernice Gideon
[1.1.1.1.4.2.3.3.4.3.7.5]
b. 17 Oct 1911 d. 27 Apr 1977 [
=>
]
12
Violet Gideon
[1.1.1.1.4.2.3.3.4.3.7.6]
b. 1914
11
Herman Sanford "Dick" Gideon
[1.1.1.1.4.2.3.3.4.3.8]
b. 11 Apr 1885 d. 3 Feb 1975
+
Florence Brewer
b. Jan 1890
Viola Izora Horne
b. 3 May 1898 d. 27 Jun 1972
12
Garnet Violet Gideon
[1.1.1.1.4.2.3.3.4.3.8.1]
b. 19 Mar 1918 d. 31 Jan 2006
12
Ross A Gideon
[1.1.1.1.4.2.3.3.4.3.8.2]
b. 9 May 1924 d. 24 Jul 2002
11
Bessie May Gideon
[1.1.1.1.4.2.3.3.4.3.9]
b. 1886
+
Robert Jackson Sackett
b. 4 Feb 1886 d. 15 Jan 1963
9
Rheuphemia Daggett
[1.1.1.1.4.2.3.3.5]
b. 19 Oct 1809
Elizabeth Tobey
b. 22 Nov 1791 d. 1862
9
Eli Daggett
[1.1.1.1.4.2.3.3.6]
b. 7 Feb 1815 d. Abt 1815
9
Polly W Daggett
[1.1.1.1.4.2.3.3.7]
b. 25 Feb 1818
9
Maria Keziah Daggett
[1.1.1.1.4.2.3.3.8]
b. 20 Apr 1820 d. 2 Dec 1883
Thomas B Muldoon
b. 1820 d. 21 Apr 1870
10
James D Muldoon
[1.1.1.1.4.2.3.3.8.1]
b. Jun 1847 d. 28 Dec 1906
Susan E Ismon
b. Feb 1853
11
Kate Muldoon
[1.1.1.1.4.2.3.3.8.1.1]
b. Abt 1876 d. Aft 1895
11
Henry James Muldoon
[1.1.1.1.4.2.3.3.8.1.2]
b. 20 Jun 1878 d. Aft 1895
11
Kenneth Thomas Muldoon
[1.1.1.1.4.2.3.3.8.1.3]
b. 26 Sep 1883 d. Aft 1895
10
Frank M Muldoon
[1.1.1.1.4.2.3.3.8.2]
b. Dec 1849
10
Clara Muldoon
[1.1.1.1.4.2.3.3.8.3]
b. Abt 1855 d. 1883
10
Frederick B Muldoon
[1.1.1.1.4.2.3.3.8.4]
b. 1858 d. 20 Feb 1888
10
Emma M Muldoon
[1.1.1.1.4.2.3.3.8.5]
b. 1863 d. 1940
9
Lyman Daggett
[1.1.1.1.4.2.3.3.9]
b. 22 Feb 1822 d. 26 Mar 1902
Mary E Belding
b. 1829 d. Bef 1900
10
Arthur B Daggett
[1.1.1.1.4.2.3.3.9.1]
b. 1856 d. Aft 1910
Madge Clark
b. Feb 1875 d. Aft 1915
11
Clark Daggett
[1.1.1.1.4.2.3.3.9.1.1]
b. Abt 1902 d. Aft 1915
11
Lenore Daggett
[1.1.1.1.4.2.3.3.9.1.2]
b. Abt 1908 d. Aft 1915
10
Freeman L Daggett
[1.1.1.1.4.2.3.3.9.2]
b. 1858 d. 14 Feb 1935
Edith E Doran
b. Sep 1868 d. Aft 1900
11
John D Daggett
[1.1.1.1.4.2.3.3.9.2.1]
b. Dec 1897 d. Aft 1900
10
Bertha E Daggett
[1.1.1.1.4.2.3.3.9.3]
b. Jul 1864 d. Aft 1900
9
Avery Tobey Daggett
[1.1.1.1.4.2.3.3.10]
b. 16 Dec 1824 d. Aft 1880
Mary S
b. Apr 1848 d. Aft 1905
10
William Lee Daggett
[1.1.1.1.4.2.3.3.10.1]
b. Jul 1869 d. Aft 1905
+
Lilly Lucretia Hale
b. 1867 d. Aft 1905
9
David Janson Daggett
[1.1.1.1.4.2.3.3.11]
b. 4 May 1827 d. 30 Dec 1894
Katherine Roddy
b. Abt 1844 d. 13 Jul 1900
10
Abner Daggett
[1.1.1.1.4.2.3.3.11.1]
b. 1861 d. Aft 1885
10
Fred E Daggett
[1.1.1.1.4.2.3.3.11.2]
b. 23 Aug 1864 d. 7 Nov 1907
10
Eldridge Daggett
[1.1.1.1.4.2.3.3.11.3]
b. Mar 1865 d. 1927
+
Isabella M Gardiner
b. Nov 1872 d. Aft 1905
10
Edward R Daggett
[1.1.1.1.4.2.3.3.11.4]
b. 1868 d. 21 Mar 1927
10
Frank M Daggett
[1.1.1.1.4.2.3.3.11.5]
b. 21 Jun 1872 d. 18 Jul 1922
Edith Price
b. 1876
11
William Rod Daggett
[1.1.1.1.4.2.3.3.11.5.1]
b. 31 May 1896 d. 23 Feb 1979
+
Jenny
b. 29 Mar 1899 d. 25 Jan 1987
10
Katheryn Carrie Daggett
[1.1.1.1.4.2.3.3.11.6]
b. 11 Sep 1878 d. 22 Jun 1958
+
Edward L Tate
b. Abt 1858 d. 3 Jan 1930
9
Cordelia Flavilla Daggett
[1.1.1.1.4.2.3.3.12]
b. 3 Feb 1831 d. Aft 1900
John R Cooley
b. 1832 d. Bef 1900
10
Ella Cooley
[1.1.1.1.4.2.3.3.12.1]
b. 1869 d. Bef 1900
9
Elizabeth Daggett
[1.1.1.1.4.2.3.3.13]
b. Dec 1833
7
Hannah Daggett
[1.1.1.1.4.2.4]
b. 23 Dec 1753
7
Martha Daggett
[1.1.1.1.4.2.5]
b. 2 Jun 1755
Edward Wheelock
b. 1754
8
Relief Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.1]
b. 2 Sep 1777
8
Silas Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2]
b. 20 Apr 1781 d. 30 Oct 1851
Rena Baldwin
b. 26 Feb 1778 d. 28 Jun 1833
9
Lewis Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.1]
b. 5 Dec 1807 d. 24 Dec 1881
Eliza Palmer
b. Abt 1813
10
Clarinda Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.1.1]
b. Abt 1832
10
Albert H Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.1.2]
b. Abt 1833 d. Aft 1912
+
Emily Hubbard
b. 1834 bur. 23 Sep 1873
10
Orlando Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.1.3]
b. 30 Jul 1834 d. 7 Nov 1900
Susan Foote
b. 14 Nov 1839
11
Flora Belle Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.1.3.1]
b. 22 Feb 1867
Orlando J Asire
b. Nov 1858 d. 1934
12
Horace W Asire
[1.1.1.1.4.2.5.2.1.3.1.1]
b. 7 Mar 1891
10
Mary Ann Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.1.4]
b. 11 Aug 1835 d. Abt 1874
Daniel Chase
b. 24 Aug 1834 d. 28 Jan 1902
11
Estella Chase
[1.1.1.1.4.2.5.2.1.4.1]
b. 22 Jan 1861
Frank Leland Alger
b. Abt 1856
12
Daughter Alger
[1.1.1.1.4.2.5.2.1.4.1.1]
b. Abt 1887
12
Daughter Alger
[1.1.1.1.4.2.5.2.1.4.1.2]
b. Abt 1889
12
Daughter Alger
[1.1.1.1.4.2.5.2.1.4.1.3]
b. Abt 1891
11
Elmer C Chase
[1.1.1.1.4.2.5.2.1.4.2]
b. 28 Dec 1865
11
Velma Chase
[1.1.1.1.4.2.5.2.1.4.3]
b. 16 Jan 1873
10
Lewis M Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.1.5]
b. Abt 1837
10
Almina Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.1.6]
b. Abt 1838
10
Fred Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.1.7]
b. Abt 1840
10
Irena Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.1.8]
b. Abt 1842
10
Cyrus Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.1.9]
b. Abt 1843
10
Phebe Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.1.10]
b. Abt 1845
9
Olive Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.2]
b. 9 Apr 1806
9
Albert Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.3]
b. 3 Jan 1805 d. 8 Jun 1875
Lisena Clark
b. 4 Jan 1811 d. 25 Jan 1894
10
Laura Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.3.1]
b. Abt 1831
10
Mariette Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.3.2]
b. Abt 1835
10
William H Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.3.3]
b. Abt 1837
10
Oscar F Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.3.4]
b. Abt 1841
Nancy
b. Abt 1845
11
Hattie Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.3.4.1]
b. Abt 1871
11
Arthur Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.3.4.2]
b. Abt 1873
11
Fred Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.3.4.3]
b. Abt 1875
11
Matie Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.3.4.4]
b. Abt 1877
9
Scinda Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.4]
b. 16 Sep 1809 d. 14 Oct 1845
+
Michael Hutchinson
9
Silas B Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.5]
b. 6 Jun 1811 d. 16 Nov 1897
Phebe Smith
b. 26 Nov 1809 d. 8 Jul 1890
10
Julia Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.5.1]
b. 7 Jan 1836 d. 19 Jan 1865
10
Jane Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.5.2]
b. 7 Jul 1838 d. 3 May 1882
+
Horace W White
d. 28 Feb 1896
10
Martha S Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.5.3]
b. 22 Sep 1840 d. 14 Nov 1899
+
Charles W Bourne
b. 1838 d. 1925
10
Hilton Haven Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.5.4]
b. 2 Apr 1843 d. 7 Oct 1925
+
Martha L Merrice
b. 1848 d. Nov 1865
Orpha Sophia Fritts
b. 4 Apr 1843 d. 27 Aug 1915
11
Frank H Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.5.4.1]
b. 3 Jan 1870 d. Jan 1946
+
Louise
b. 1870 d. 1927
11
Clara Josephine Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.5.4.2]
b. 13 Oct 1874 d. 14 Jan 1965
+
Harry Arnold Titus
b. 11 May 1880 d. 1953
11
Alton R Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.5.4.3]
b. 27 Feb 1880 d. 1 Apr 1964
Louella Willett
b. 1884 d. 1958
12
Lawrence Eugene Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.5.4.3.1]
b. 19 Oct 1911 d. Aug 1945
12
Ruth Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.5.4.3.2]
b. 1915 d. 1915
12
Alton Ray Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.5.4.3.3]
b. 27 May 1920 d. 12 Dec 1986
9
John Homer Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.6]
b. 26 May 1813 d. 28 Mar 1887
Sarah L Houghton
b. 29 Apr 1816 d. 16 Nov 1890
10
Amelia Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.6.1]
b. 1843 d. 1925
M Lafayette Ranlett
b. 1838 d. 1925
11
Ida Ranlett
[1.1.1.1.4.2.5.2.6.1.1]
11
Lois Ranlett
[1.1.1.1.4.2.5.2.6.1.2]
11
William H Ranlett
[1.1.1.1.4.2.5.2.6.1.3]
b. 14 Oct 1878 d. 8 Aug 1950
Nellie Brehm
12
Ruth Ranlett
[1.1.1.1.4.2.5.2.6.1.3.1]
b. 1904
12
Herman L Ranlett
[1.1.1.1.4.2.5.2.6.1.3.2]
b. 1908
10
Theodore Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.6.2]
b. 5 May 1844 d. 31 Dec 1898
Clarabelle Miller
b. 3 May 1851 d. 12 Nov 1904
11
William Homer Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.6.2.1]
b. 15 Oct 1886 d. 19 Oct 1975
+
Florence Mable Cave
b. 16 Mar 1885 d. 3 Dec 1961
10
Agustus J Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.6.3]
b. 29 Dec 1848
10
Augusta Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.6.4]
b. 29 Dec 1848 d. 1900
10
Zenas Elmer Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.6.5]
b. 14 Apr 1849 d. 14 Feb 1926
+
Emma L Tanner
b. 5 Jan 1857 d. 22 Aug 1890
10
Delia Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.6.6]
b. 18 Aug 1853 d. 4 Apr 1914
10
Delitah Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.6.7]
b. 18 Aug 1853 d. 1934
9
Harmon Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.7]
b. 13 Mar 1815 d. 1892
+
Amanda S Hill
b. Abt 1807 d. 27 Dec 1893
9
Nancy B Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.8]
b. 17 Sep 1817 d. 20 Dec 1842
9
Joseph S Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.9]
b. 1 Nov 1819 d. 21 Apr 1902
Paula Almira Crandall
b. 19 Sep 1826 d. 1899
10
Silas Stanton Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.9.1]
b. 30 Jun 1851 d. 25 Feb 1931
Nettie Marilla Crumb
b. 3 Aug 1855 d. 8 Nov 1950
11
Edith May Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.9.1.1]
b. 18 May 1883 d. 21 Oct 1956
Abraham Murphy Mains
b. 3 Aug 1872 d. 12 Feb 1967
12
Genevieve Mains
[1.1.1.1.4.2.5.2.9.1.1.1]
b. 1 Mar 1909 d. 17 Jul 2002
11
Genevieve Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.9.1.2]
b. 13 Nov 1888
Robert Christine
b. 15 Jan 1888
12
Ralph Christine
[1.1.1.1.4.2.5.2.9.1.2.1]
b. 15 Oct 1910 d. 5 Mar 1928
11
Bertha Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.9.1.3]
b. 28 Aug 1890
+
Will E Abrams
b. 8 Mar 1873
11
Delia Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.9.1.4]
b. 4 Nov 1893 d. 21 Feb 1981
+
Ernest G Rees
b. 9 Jul 1892 d. 9 Oct 1976
10
Mary J Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.9.2]
b. 22 Nov 1852 d. 28 Sep 1870
10
Florence Ann Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.9.3]
b. 7 Jun 1854 d. May 1916
Edgar Jay
b. 3 Feb 1844 d. 14 May 1914
11
Floyd H Jay
[1.1.1.1.4.2.5.2.9.3.1]
b. 6 May 1876 d. 6 Oct 1965
+
Bessie Sharp Lilley
b. 22 Jul 1886
11
Girdon E Jay
[1.1.1.1.4.2.5.2.9.3.2]
b. 5 Jul 1878
10
Millard Fillmore Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.9.4]
b. 27 Aug 1856 d. 15 Feb 1931
Persis Ellen Lewis
b. 18 Dec 1861 d. 20 Jan 1900
11
Dime H Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.9.4.1]
b. 1 Oct 1884 d. 6 Jul 1961
+
Edmond George Crowell
b. 18 May 1882 d. 11 Mar 1931
11
Maurice J Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.9.4.2]
b. 26 Nov 1886 d. 6 Dec 1975
+
Charlotte Counradt
b. 20 Mar 1883 d. 21 Apr 1966
11
Julia Nell Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.9.4.3]
b. 25 Mar 1889 d. 13 Nov 1941
Clarence Park
b. 24 Mar 1885 d. 8 Mar 1965
12
Helen E Park
[1.1.1.1.4.2.5.2.9.4.3.1]
b. 31 Jul 1911 d. 22 Jun 1966
11
Ellis Harold Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.9.4.4]
b. 29 Apr 1891 d. 14 Feb 1963
Josephine Else
b. 1889 d. 10 Feb 1918
12
Robert Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.9.4.4.1]
b. 3 Apr 1915 d. 9 May 1996
Marion Fawcett
b. 10 Jul 1903 d. 25 May 1995
12
Walter Ellis Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.9.4.4.2]
b. 9 Sep 1925 d. 29 Aug 1986
12
Betty Jean Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.9.4.4.3]
b. 1 Mar 1929 d. 27 Feb 2007
11
Doris Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.9.4.5]
b. 5 Mar 1899 d. 19 Sep 1962
10
Lillian Victoria Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.9.5]
b. 29 Jul 1858 d. 1 Oct 1907
Phiny Shattuck
b. 21 Jun 1863 d. 24 Jan 1919
11
Charles L Shattuck
[1.1.1.1.4.2.5.2.9.5.1]
b. 24 Nov 1889 d. 29 Oct 1956
11
Elmer B Shattuck
[1.1.1.1.4.2.5.2.9.5.2]
b. 9 Oct 1893 d. 13 Feb 1976
+
Laura Gertrude Robinson
b. 24 Oct 1892
9
Zenas S Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.10]
b. 29 Aug 1821 d. 25 May 1844
9
James Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.11]
b. 4 Jul 1824
9
Sophronia Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.2.12]
b. 25 Oct 1826
+
George Smith
+
Sarah Hurlbut
b. 21 Mar 1790 d. 1855
8
Lynda Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.3]
b. 15 Apr 1783
8
Reuben Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.4]
b. 23 Jul 1785 d. 29 Jul 1833
Rosanna Smiley
b. 5 Jun 1783 d. 30 Apr 1874
9
Agusta Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.4.1]
b. Abt 1806
9
Gillman Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.4.2]
b. Abt 1808
9
Sarah Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.4.3]
b. Abt 1810
9
Eliza Ann Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.4.4]
b. Abt 1812
9
Laurane Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.4.5]
b. 1 Sep 1814 d. 24 Mar 1884
Frederick S Benham
b. 2 Jan 1811 d. 21 Jul 1861
10
Mary Eliza Benham
[1.1.1.1.4.2.5.4.5.1]
b. 1835 d. 31 Aug 1873
Benjamin V Ensley
b. 16 Apr 1830 d. 12 Dec 1889
11
Marie E Ensley
[1.1.1.1.4.2.5.4.5.1.1]
b. 1856
11
William B Ensley
[1.1.1.1.4.2.5.4.5.1.2]
b. 1858 d. 1903
Estella Dozunbery
b. Nov 1871
12
William B Ensley
[1.1.1.1.4.2.5.4.5.1.2.1]
b. Apr 1890
12
Benjamin T Ensley
[1.1.1.1.4.2.5.4.5.1.2.2]
b. Feb 1891
12
Milford M Ensley
[1.1.1.1.4.2.5.4.5.1.2.3]
b. Dec 1896
11
Eliza A Ensley
[1.1.1.1.4.2.5.4.5.1.3]
b. Dec 1859
11
Benjamin F Ensley
[1.1.1.1.4.2.5.4.5.1.4]
b. Dec 1861
Edith Estella Hallock
b. Oct 1867
12
Bertha L Ensley
[1.1.1.1.4.2.5.4.5.1.4.1]
b. Aug 1889
12
Lena L Ensley
[1.1.1.1.4.2.5.4.5.1.4.2]
b. Mar 1892
11
Frank D Ensley
[1.1.1.1.4.2.5.4.5.1.5]
b. 24 Apr 1865 d. Apr 1866
11
Antoinette Ensley
[1.1.1.1.4.2.5.4.5.1.6]
b. 2 Jul 1867 d. 1918
James Watts
b. 1856
12
Fannie D Watts
[1.1.1.1.4.2.5.4.5.1.6.1]
b. Jul 1884
11
Laurane Ensley
[1.1.1.1.4.2.5.4.5.1.7]
b. 8 Jun 1868
11
John Ensley
[1.1.1.1.4.2.5.4.5.1.8]
b. 31 Aug 1873 d. Sep 1873
10
Fernando Benham
[1.1.1.1.4.2.5.4.5.2]
b. 15 Nov 1836 d. 7 Feb 1900
Malony Malora Parkinson
b. 17 Jun 1844 d. 1927
11
Addie Adell Benham
[1.1.1.1.4.2.5.4.5.2.1]
b. 23 Feb 1864 d. 16 Nov 1943
Clarence Jerome Phelps
b. Aug 1862 d. 19 Aug 1932
12
Lola Adell Phelps
[1.1.1.1.4.2.5.4.5.2.1.1]
b. 9 Apr 1885 d. 1919 [
=>
]
12
Edgar Phelps
[1.1.1.1.4.2.5.4.5.2.1.2]
b. 27 Jun 1890 [
=>
]
12
Malora K Phelps
[1.1.1.1.4.2.5.4.5.2.1.3]
b. 8 Aug 1899
12
Melvia C Phelps
[1.1.1.1.4.2.5.4.5.2.1.4]
b. 8 Aug 1899
12
Elnora Phelps
[1.1.1.1.4.2.5.4.5.2.1.5]
b. 28 May 1903 d. 30 Apr 1986
12
Jerome B Phelps
[1.1.1.1.4.2.5.4.5.2.1.6]
b. 23 Jan 1911 d. 1 May 2007
11
Samuel H Benham
[1.1.1.1.4.2.5.4.5.2.2]
b. 21 Feb 1866 d. 31 Mar 1911
+
Effie G Turner
Elizabeth Schouten
b. 1875
12
DeForrest Benham
[1.1.1.1.4.2.5.4.5.2.2.1]
b. Aug 1899 d. 11 Dec 1906
11
James F Benham
[1.1.1.1.4.2.5.4.5.2.3]
b. 3 Mar 1868
11
Clinton G Benham
[1.1.1.1.4.2.5.4.5.2.4]
b. Dec 1870 d. 9 Apr 1923
Ettie Correll
12
Gratia "Grace" Benham
[1.1.1.1.4.2.5.4.5.2.4.1]
b. 1893
12
Clinton G Benham, Jr
[1.1.1.1.4.2.5.4.5.2.4.2]
b. 27 Jun 1900 [
=>
]
11
Frank W Benham
[1.1.1.1.4.2.5.4.5.2.5]
b. 13 Apr 1871
10
Maria A Benham
[1.1.1.1.4.2.5.4.5.3]
b. 1838 d. 1854
10
James Louis Benham
[1.1.1.1.4.2.5.4.5.4]
b. 1841 d. 1861
10
Elizabeth Benham
[1.1.1.1.4.2.5.4.5.5]
b. 1843
10
Frederick S Benham, Jr
[1.1.1.1.4.2.5.4.5.6]
b. 1846
10
Francis M Benham
[1.1.1.1.4.2.5.4.5.7]
b. 1849 d. 1915
10
Charles W Benham
[1.1.1.1.4.2.5.4.5.8]
b. 1853 d. 1900
9
Emmons Howe Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.4.6]
b. 17 May 1817 d. 27 Apr 1899
Polly Wilson
b. Abt 1824 d. 6 Dec 1904
10
Mary Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.4.6.1]
b. 19 Jan 1848
10
George Washington Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.4.6.2]
b. 25 Dec 1849 d. 21 Jan 1935
Grace Amelia O'dell
11
Clifford Judson Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.4.6.2.1]
b. 6 Jun 1879 d. 1943
+
Dora Killgore
11
Charles Emmons Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.4.6.2.2]
b. 1 Jan 1881 d. 21 Oct 1966
+
Elsie Sophie Metzger
b. 20 Apr 1885 d. 1 Sep 1966
11
Frank Seldon Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.4.6.2.3]
b. 16 Apr 1883 d. 1942
+
Ora Storer
11
Glanis Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.4.6.2.4]
b. 5 Sep 1885
11
Glenn E Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.4.6.2.5]
b. 6 Sep 1886 d. 1975
+
Lura V Parker
b. 18 Oct 1893 d. 15 Aug 1961
11
Fern Lenora Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.4.6.2.6]
b. 1 Mar 1891 d. 4 Oct 1976
11
Herbert Lee Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.4.6.2.7]
b. 10 Aug 1894
10
Warren J Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.4.6.3]
b. 16 Mar 1851 d. 23 Feb 1934
Florence Amanda Haynes
b. 21 Mar 1854 d. 10 Dec 1929
11
Blanche Jane Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.4.6.3.1]
b. 8 Oct 1885 d. 24 Apr 1944
Ansley Thomas Goddard
b. 3 Oct 1879 d. 3 Mar 1940
12
Son Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.4.6.3.1.1]
b. 25 May 1916 d. 25 May 1916
10
Marion Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.4.6.4]
b. 12 Aug 1852 d. 19 Mar 1926
10
Eliza Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.4.6.5]
b. 26 Apr 1855 d. 21 Apr 1934
10
Martin Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.4.6.6]
b. 18 Jul 1856 d. 19 Oct 1923
10
Arthur Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.4.6.7]
b. 7 Mar 1858 d. 29 Dec 1937
10
Selden Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.4.6.8]
b. 24 Dec 1859 d. 9 Oct 1933
Nancy Bond
b. Apr 1869
11
Donald J Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.4.6.8.1]
b. 1911 d. 2006
10
Amos Solon Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.4.6.9]
b. Abt 1861 d. 1887
10
Olive L Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.4.6.10]
b. 25 Apr 1868 d. 10 Oct 1932
+
Emanuel H Koch
10
Ada Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.4.6.11]
b. Abt 1870
9
Caroline Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.4.7]
b. 29 Sep 1819
9
Andrew Jackson Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.4.8]
b. 1 Jun 1822 d. 31 May 1915
Mary Ann Gregory
b. 1 Jul 1826
10
Leah Josephine Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.4.8.1]
b. 14 Dec 1849
Bridget Mary Evans
b. 27 Dec 1826 d. 4 Apr 1904
10
William A Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.4.8.2]
b. 31 Jul 1856 d. 1862
10
Mary Elizabeth Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.4.8.3]
b. 21 Nov 1858 d. 15 Jul 1932
Eugene Horace Chamberlain
b. 21 Mar 1855 d. 5 May 1930
11
Clara Elizabeth Chamberlain
[1.1.1.1.4.2.5.4.8.3.1]
b. 12 Sep 1887 d. 4 Jan 1959
William Richard Pollard
b. 11 Feb 1866 d. 23 Apr 1952
12
Monica Alice Pollard
[1.1.1.1.4.2.5.4.8.3.1.1]
b. 22 Feb 1915 d. 13 Mar 1968
12
Joseph Clayton Pollard
[1.1.1.1.4.2.5.4.8.3.1.2]
b. 17 May 1916 d. 13 May 1983 [
=>
]
12
James Eugene Pollard
[1.1.1.1.4.2.5.4.8.3.1.3]
b. 14 Jun 1918 d. 16 Apr 1996
12
Dale Vincent Pollard
[1.1.1.1.4.2.5.4.8.3.1.4]
b. 11 Jun 1921 d. 11 Feb 1972
12
Lorin Matthew Pollard
[1.1.1.1.4.2.5.4.8.3.1.5]
b. 10 Apr 1923 d. 18 Dec 1991
12
George William Pollard
[1.1.1.1.4.2.5.4.8.3.1.6]
b. 22 Feb 1928 d. 29 Sep 1994
12
Clyde Leon Pollard
[1.1.1.1.4.2.5.4.8.3.1.7]
b. 29 Mar 1930 d. 27 Jul 1992
11
Edward Clayton Chamberlain
[1.1.1.1.4.2.5.4.8.3.2]
b. 14 Jan 1889 d. Abt 1970
+
Catherine Ellen Hickey
b. 26 Dec 1884 d. 1948
11
Ralph Leo Chamberlain
[1.1.1.1.4.2.5.4.8.3.3]
b. 17 Jul 1890 d. 6 Dec 1978
Rose Lena Hickey
b. 6 Dec 1890 d. 19 Dec 1971
12
Mary Rosalie Chamberlain
[1.1.1.1.4.2.5.4.8.3.3.1]
b. 24 Nov 1913 d. 24 Nov 1913
11
George Wallace Chamberlain
[1.1.1.1.4.2.5.4.8.3.4]
b. 28 May 1892 d. 3 Feb 1962
+
Rosella M O'Neil
b. 2 Feb 1896 d. 9 Oct 1939
11
Alice Mary Chamberlain
[1.1.1.1.4.2.5.4.8.3.5]
b. 21 Apr 1895 d. 6 Jul 1972
+
William Henry Bennett
b. 21 Jan 1900 d. 13 Jul 1976
11
Joseph E Chamberlain
[1.1.1.1.4.2.5.4.8.3.6]
b. 25 Jan 1900 d. 8 Aug 1902
10
George Harold Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.4.8.4]
b. 28 Oct 1860
Elizabeth Sherwood
b. Jan 1872
11
George Harold Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.4.8.4.1]
b. 20 Jul 1899 d. 1985
11
Howard Andrew Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.4.8.4.2]
b. 21 Feb 1905 d. 25 Dec 1988
11
Robert E Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.4.8.4.3]
b. 1909 d. 1995
10
Rosanna William Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.4.8.5]
b. 23 Dec 1862 d. 1869
10
Charles J Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.4.8.6]
b. 1864 d. 1869
10
Charles J Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.4.8.7]
9
James Loren Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.4.9]
b. 28 Feb 1825 d. 6 Dec 1900
Irene Jane Haynes
b. 20 Nov 1827 d. 20 Feb 1905
10
Son Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.4.9.1]
b. 1848 d. 1848
10
Judson Wells Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.4.9.2]
b. 30 Dec 1851 d. 23 Oct 1936
Sarah Suddaby
b. 20 Mar 1857 d. 22 Apr 1915
11
Ora Arminta Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.4.9.2.1]
b. 23 Jun 1877 d. 27 Sep 1944
Franklin Clarence Hollis
b. 23 Aug 1875 d. 12 Jan 1956
12
Leone Hollis
[1.1.1.1.4.2.5.4.9.2.1.1]
b. 2 Aug 1898 d. 15 Sep 1899
12
Cleo E Hollis
[1.1.1.1.4.2.5.4.9.2.1.2]
b. 31 Oct 1902 d. 8 Jun 1903
12
Norval Hollis
[1.1.1.1.4.2.5.4.9.2.1.3]
b. 31 Jul 1905 d. 12 Sep 1906
12
Daughter Hollis
[1.1.1.1.4.2.5.4.9.2.1.4]
b. Oct 1920 d. Oct 1920
11
Dott Irene Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.4.9.2.2]
b. 27 Nov 1880 d. 15 Jan 1964
11
John Blakselee Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.4.9.2.3]
b. 17 Jan 1887
11
Ward Suddaby Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.4.9.2.4]
b. 7 Aug 1893
10
Antonette Jane Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.4.9.3]
b. 4 Jul 1856 d. 6 Apr 1863
10
Cora Marietta Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.4.9.4]
b. 26 Nov 1859 d. 19 Feb 1896
10
Rose Jane Wheelock
[1.1.1.1.4.2.5.4.9.5]
b. 8 Dec 1871 d. 1 Feb 1894
7
Aaron Daggett
[1.1.1.1.4.2.6]
b. 12 Mar 1757 d. 3 Jun 1759
7
Lidia Daggett
[1.1.1.1.4.2.7]
b. 4 Oct 1758 d. 23 Mar 1836
Naham Lamb
b. 13 Jul 1759 d. 22 May 1842
8
Amasa Lamb
[1.1.1.1.4.2.7.1]
b. 24 Jul 1786 d. 12 Jun 1815
8
Linda Lamb
[1.1.1.1.4.2.7.2]
b. 14 Oct 1788
+
Caleb Knight
b. 16 Sep 1780
8
Patee Lamb
[1.1.1.1.4.2.7.3]
b. 10 Jan 1791
8
Nahum Lamb
[1.1.1.1.4.2.7.4]
b. 4 Aug 1793
8
Lydia Lamb
[1.1.1.1.4.2.7.5]
b. 3 Feb 1796
8
Jason Lamb
[1.1.1.1.4.2.7.6]
b. 9 Oct 1798 d. 2 Aug 1873
Nancy Cruver
b. 5 Nov 1804 d. 14 Nov 1843
9
Salem Towne Lamb
[1.1.1.1.4.2.7.6.1]
b. 15 Oct 1823
9
George Washington Lamb
[1.1.1.1.4.2.7.6.2]
b. 1825
9
Erastus Wallace Lamb
[1.1.1.1.4.2.7.6.3]
b. 1826
9
Melinda Mary Lamb
[1.1.1.1.4.2.7.6.4]
b. 1829
9
Leonard Lamb
[1.1.1.1.4.2.7.6.5]
b. 1830 d. 1858
Melinda W Harmon
b. 17 Apr 1810 d. 31 Aug 1883
9
Ellen E Lamb
[1.1.1.1.4.2.7.6.6]
b. 1846 d. Bef 1923
Charles Henry Williams
b. 21 Jun 1845 d. 5 Jan 1911
10
Thomas Harmon Williams
[1.1.1.1.4.2.7.6.6.1]
b. 1867
10
Lora A Williams
[1.1.1.1.4.2.7.6.6.2]
b. 1871
10
Wallace J Williams
[1.1.1.1.4.2.7.6.6.3]
b. 1874
10
Kate Williams
[1.1.1.1.4.2.7.6.6.4]
b. 1877
9
Asenath H Lamb
[1.1.1.1.4.2.7.6.7]
b. Abt 1849 d. Bef 1923
9
Kate Lamb
[1.1.1.1.4.2.7.6.8]
b. 19 Dec 1853 d. 11 Jul 1936
Seba Samuel Bedient
b. 27 Aug 1855 d. 21 Jun 1917
10
Ona Elizabeth Bedient
[1.1.1.1.4.2.7.6.8.1]
b. 31 Jan 1881 d. 8 Sep 1936
10
Mary M Bedient
[1.1.1.1.4.2.7.6.8.2]
b. 10 Jun 1888
+
Ira W Livermore
b. Abt 1886
8
Gerson Lamb
[1.1.1.1.4.2.7.7]
b. 8 Aug 1800 d. 13 Nov 1885
Lois Fisk Bacon
b. 11 Nov 1801 d. 4 Sep 1884
9
Norval Bacon Lamb
[1.1.1.1.4.2.7.7.1]
b. 17 Apr 1827
9
Alvan Naham Lamb
[1.1.1.1.4.2.7.7.2]
b. 27 Jul 1828
9
Edwin Dagget Lamb
[1.1.1.1.4.2.7.7.3]
b. 18 Jul 1832
9
Henry Gersom Lamb
[1.1.1.1.4.2.7.7.4]
b. 27 Feb 1834
Ellen Augusta Bacon
b. 9 Nov 1838
10
Frank Henry Lamb
[1.1.1.1.4.2.7.7.4.1]
b. 14 Jun 1856
9
Theodore Fiske Lamb
[1.1.1.1.4.2.7.7.5]
b. 2 Sep 1836
9
Charles Francis Lamb
[1.1.1.1.4.2.7.7.6]
b. 15 Mar 1838
8
Washington Lamb
[1.1.1.1.4.2.7.8]
b. 6 May 1803
6
William Daggett
[1.1.1.1.4.3]
b. 15 Aug 1727 d. 15 Jan 1813
Thankful Gleason
b. 17 Jun 1738 d. 28 Dec 1813
7
Asa Daggett
[1.1.1.1.4.3.1]
b. 7 Jul 1760 d. Abt 1830
Waitstill Monroe
b. 2 Jan 1764
8
Asel Daggett
[1.1.1.1.4.3.1.1]
b. 16 Aug 1798 d. 6 Jan 1848
Elizabeth Barnes
b. 1804 d. 1 Jul 1891
9
Ann Elizabeth Daggett
[1.1.1.1.4.3.1.1.1]
b. 13 Mar 1829 d. 21 Feb 1901
Luke Teeple
b. Abt 1828 d. 11 Feb 1923
10
Matilda E Teeple
[1.1.1.1.4.3.1.1.1.1]
b. 1 Oct 1848 d. 12 Oct 1951
Edgar A Manning
b. 12 Dec 1844 d. 1907
11
William August Manning
[1.1.1.1.4.3.1.1.1.1.1]
b. 14 Mar 1866 d. 11 Oct 1873
11
James A Manning
[1.1.1.1.4.3.1.1.1.1.2]
b. 10 Feb 1870
11
Minnie E Manning
[1.1.1.1.4.3.1.1.1.1.3]
b. 12 Oct 1872 d. 26 Aug 1913
Josias F Corey
b. 1865
12
Silas J Corey
[1.1.1.1.4.3.1.1.1.1.3.1]
b. 1891
12
Floyd Fay Corey
[1.1.1.1.4.3.1.1.1.1.3.2]
b. 3 Apr 1893 d. 2 Apr 1979 [
=>
]
12
Ruth A Corey
[1.1.1.1.4.3.1.1.1.1.3.3]
b. 1897
12
Tedy R Corey
[1.1.1.1.4.3.1.1.1.1.3.4]
b. 1902
11
Nellie Ann Manning
[1.1.1.1.4.3.1.1.1.1.4]
b. 31 Aug 1875 d. 17 Oct 1972
Edgar Fayette Ellsworth
b. Oct 1869 d. 5 Jul 1949
12
Susan Ilo Ellsworth
[1.1.1.1.4.3.1.1.1.1.4.1]
b. 16 Apr 1894 d. 14 Nov 1984 [
=>
]
12
Helen B Ellsworth
[1.1.1.1.4.3.1.1.1.1.4.2]
b. Mar 1897
12
Alice Ellsworth
[1.1.1.1.4.3.1.1.1.1.4.3]
b. Jul 1899
11
Luke Philip Manning
[1.1.1.1.4.3.1.1.1.1.5]
b. 3 May 1878 d. 19 Jan 1969
+
Nellie Lewison
b. 11 Feb 1886 d. 1948
11
Clarence Gilbert Manning
[1.1.1.1.4.3.1.1.1.1.6]
b. 15 May 1881 d. 12 Oct 1960
+
Katherine Diana Garver
b. 3 Jul 1883 d. 27 Jul 1950
11
Dell Lee Manning
[1.1.1.1.4.3.1.1.1.1.7]
b. 5 Apr 1884 d. 11 Apr 1975
Edith Whithnell
b. 1 Aug 1883 d. 8 Jul 1970
12
Viola Manning
[1.1.1.1.4.3.1.1.1.1.7.1]
b. 1915 d. 1915
12
Lyle Luke Manning
[1.1.1.1.4.3.1.1.1.1.7.2]
b. 16 Apr 1917 d. 16 Jun 1985
12
Dellamae Manning
[1.1.1.1.4.3.1.1.1.1.7.3]
b. 12 Jan 1927 d. 21 Jun 2002
11
Harry Manning
[1.1.1.1.4.3.1.1.1.1.8]
b. Mar 1889 bur. 25 Jun 1914
11
Asa William Manning
[1.1.1.1.4.3.1.1.1.1.9]
b. 3 May 1891 d. 15 Jun 1974
10
George Teeple
[1.1.1.1.4.3.1.1.1.2]
b. Abt 1852 d. 27 Jan 1941
+
Ida Darval
b. 1861
10
Edgar Elisha Teeple
[1.1.1.1.4.3.1.1.1.3]
b. 1855 d. 25 Dec 1942
Idell Percey
b. 16 Mar 1860
11
Beulah Teeple
[1.1.1.1.4.3.1.1.1.3.1]
b. 4 May 1891 d. Sep 1913
10
Asa Henry Teeple
[1.1.1.1.4.3.1.1.1.4]
b. 23 Mar 1857 d. 18 May 1940
Mary Elizabeth Dawson
b. 1 Nov 1857 d. 28 May 1943
11
Guy H Teeple
[1.1.1.1.4.3.1.1.1.4.1]
b. 2 Oct 1876 d. Sep 1963
Amelia Leucretia Kent
b. 5 Oct 1882 d. 3 May 1972
12
Luke Henry Teeple
[1.1.1.1.4.3.1.1.1.4.1.1]
b. 9 Sep 1906 d. Sep 1961
12
Harold Teeple
[1.1.1.1.4.3.1.1.1.4.1.2]
b. 1913
11
Anna Elizabeth Teeple
[1.1.1.1.4.3.1.1.1.4.2]
b. 20 Nov 1878 d. 23 Nov 1963
Jame Delbert Kent
b. 1 Jan 1875 d. 3 Apr 1953
12
Craig Teeple Kent
[1.1.1.1.4.3.1.1.1.4.2.1]
b. 17 Apr 1904 d. 30 May 1988
12
Esther Elizabeth Kent
[1.1.1.1.4.3.1.1.1.4.2.2]
b. 25 Aug 1905 d. Sep 1962
12
Ruth Emily Kent
[1.1.1.1.4.3.1.1.1.4.2.3]
b. 12 Jun 1909 d. 7 Nov 2001
12
Monroe Fenton Kent
[1.1.1.1.4.3.1.1.1.4.2.4]
b. 10 Apr 1911 d. 26 Dec 1991
12
Mary Margaret Kent
[1.1.1.1.4.3.1.1.1.4.2.5]
b. 23 Aug 1918 d. 26 Aug 1918
10
Helen Elizabeth Teeple
[1.1.1.1.4.3.1.1.1.5]
b. 19 Apr 1857 d. 1904
10
Simon Peter Teeple
[1.1.1.1.4.3.1.1.1.6]
b. 1860
Clara Marean
b. 1863
11
Glenn R Teeple
[1.1.1.1.4.3.1.1.1.6.1]
b. 1891
11
Jennie Adell Teeple
[1.1.1.1.4.3.1.1.1.6.2]
b. 4 Mar 1893
10
Jessie Teeple
[1.1.1.1.4.3.1.1.1.7]
b. 6 Jul 1860 d. 8 Apr 1862
10
Minnie E Teeple
[1.1.1.1.4.3.1.1.1.8]
b. 15 Sep 1862 d. 7 Nov 1870
10
Florence A Teeple
[1.1.1.1.4.3.1.1.1.9]
b. 1864
+
Jaron L Marks
10
Sherman Ulyssees Teeple
[1.1.1.1.4.3.1.1.1.10]
b. 27 Sep 1869
+
Mary E Davis
b. 23 Sep 1869
9
Jefferson Loren Daggett
[1.1.1.1.4.3.1.1.2]
b. 1 Jan 1838 d. 16 Jun 1919
Mary Jane Ward
b. 6 Aug 1842 d. 14 Feb 1899
10
William Henry Daggett
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.1]
b. 16 Feb 1862 d. 27 May 1918
Sarah Ann Lord
b. 4 May 1861 d. 14 Jun 1932
11
Bertha Jane Daggett
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.1.1]
b. 28 Mar 1883 d. 23 Jun 1965
11
Dora Adelia Daggett
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.1.2]
b. 29 Aug 1886 d. 13 Oct 1968
11
Earl Henry Daggett
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.1.3]
b. 11 Nov 1888 d. 26 Nov 1947
+
Katherine Lelia Hursh
b. 3 Aug 1888 d. 11 Feb 1970
11
Edith Ethel Daggett
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.1.4]
b. 18 Nov 1893
11
Erwin J Daggett
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.1.5]
b. 6 Jun 1898 d. 3 Dec 1968
10
Elisha Strong Daggett
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.2]
b. 7 Dec 1868 d. 16 Oct 1946
Edith F Wheeler
b. 23 Feb 1871 d. 1 Oct 1963
11
Harry Arthur Daggett
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.2.1]
b. 5 Oct 1890
11
Roy Jefferson Daggett
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.2.2]
b. 30 Dec 1893 d. 8 May 1972
Elsie Bowman
b. 31 Oct 1907 d. 17 Jul 1993
12
Donald Elisha Daggett
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.2.2.1]
b. 27 Oct 1930 d. 20 Apr 2001
11
Robert Charles Daggett
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.2.3]
b. 22 Jan 1896 d. 3 Aug 1948
11
Mary Daggett
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.2.4]
b. Aug 1898
11
Jessie I Daggett
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.2.5]
b. 2 Feb 1902 d. Dec 1987
Arthur Lars Gronwall
b. 2 Jun 1901 d. 24 Mar 1994
12
Raymond A Gronwall
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.2.5.1]
b. 26 Oct 1928 d. Dec 1981
11
Ethel Daggett
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.2.6]
b. 1906
10
Orlen Asa Daggett
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.3]
b. 15 Aug 1869 d. 22 Nov 1948
Elma Jeanette Boyington
b. 22 Jun 1874 d. 6 Apr 1904
11
Lilly Emerille Daggett
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.3.1]
b. 12 May 1892 d. 28 Jul 1980
George W Prentice
b. 27 Oct 1887 d. 16 Oct 1964
12
Mina Mae Prentice
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.3.1.1]
b. 30 Jun 1909 d. 12 Feb 2006
12
Mahala LaSalle Prentice
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.3.1.2]
b. 21 Jul 1910 d. 6 Aug 1984
12
Orlen LeRoy Prentice
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.3.1.3]
b. 8 Feb 1912 d. 13 Mar 1981
12
Rose Elma Prentice
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.3.1.4]
b. 25 Jun 1914 d. 1 May 1989
12
Jesse Wybert Prentice
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.3.1.5]
b. 14 May 1919 d. 8 Jan 1981
12
Lera June Prentice
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.3.1.6]
b. 8 Mar 1921 d. 5 Dec 1934
12
Dorothy Irenee Prentice
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.3.1.7]
b. 12 Aug 1923 d. 5 Dec 1934
12
Hazel LaVone Prentice
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.3.1.8]
b. 1 Sep 1925 d. 1 Apr 1991
12
Robert Arnold Prentice
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.3.1.9]
b. 15 Mar 1926 d. 28 Sep 2007
11
Rose Ethel Daggett
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.3.2]
b. 11 Oct 1893 d. 8 Feb 1970
Ray Herder Scott
b. 11 Nov 1890 d. 14 Nov 1965
12
Mary Jeanette Scott
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.3.2.1]
b. 4 Apr 1912 d. 28 Nov 1974 [
=>
]
12
Floyd Lee Scott
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.3.2.2]
b. 20 May 1915 d. 16 Jul 1928
12
Irene Rose Scott
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.3.2.3]
b. 14 Apr 1919 d. 8 Dec 1989
11
Bertha Daggett
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.3.3]
b. 1895 d. 1900
11
Silas Orlin Daggett
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.3.4]
b. 1 Apr 1898 d. 8 Feb 1970
+
Pearl Agnes Walker
b. 3 Jun 1902 d. 12 Nov 1992
11
Ruby Janette Daggett
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.3.5]
b. 3 Jan 1900 d. 30 Aug 1953
Thomas Blanton
b. 15 Mar 1887 d. Oct 1971
12
Margaret Blanton
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.3.5.1]
b. 6 Aug 1922 d. Feb 1986
12
Eugene Blanton
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.3.5.2]
b. 25 Jun 1933 d. Jan 1981
11
Pearl Faith Daggett
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.3.6]
b. 19 Jul 1902 d. 15 Jan 1984
David Melvin McArthur
b. 29 Jan 1894 d. 9 Apr 1960
12
Leota Joyce McArthur
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.3.6.1]
b. 27 Jun 1927 d. 1 Oct 2000
12
Barbara June McArthur
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.3.6.2]
b. 7 Apr 1933 d. 22 Feb 1987 [
=>
]
11
Jay Spencer Daggett
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.3.7]
b. 6 Apr 1904 d. 28 Sep 1958
10
Loran Elias Daggett
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.4]
b. 6 Jun 1872 d. 18 Mar 1935
Myra May Butler
b. Abt 1870
11
Leon L Daggett
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.4.1]
b. 1895
10
Andrew James Daggett
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.5]
b. 3 Feb 1874 d. 5 Feb 1936
Maude Annie Butler
b. Abt 1874
11
Florence M Daggett
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.5.1]
b. 1900
11
Hazel Daggett
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.5.2]
b. 1904
10
Truman Briant Daggett
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.6]
b. 6 Mar 1876 d. 31 Oct 1955
Ella May Earl
b. 22 Oct 1878 d. 25 Jun 1939
11
Floyd E Daggett
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.6.1]
b. 3 Aug 1905 d. Aug 1980
11
Nellie Viola Daggett
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.6.2]
b. 15 Dec 1906 d. 19 Mar 2007
11
Richard J Daggett
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.6.3]
b. 8 Mar 1915 d. Nov 1969
10
Homer Daggett
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.7]
b. Abt 1877
10
Charles Grant Daggett
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.8]
b. 29 Sep 1880 d. 14 Oct 1943
Violet May Bumpus
11
Harley L Daggett
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.8.1]
b. 5 Dec 1913 d. 15 Sep 1998
10
Delbert LeRoy Daggett
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.9]
b. 2 Sep 1882 d. 4 Jun 1951
Selma Rohde
b. Abt 1882 d. 1932
11
Loren Julius Daggett
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.9.1]
b. 2 Nov 1915 d. 29 Nov 1988
11
LeRoy Daggett
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.9.2]
b. 1 Aug 1925 d. 9 Dec 1991
11
James Daggett
[1.1.1.1.4.3.1.1.2.9.3]
b. 14 Nov 1929 d. Aug 1987
+
Myrtle May Linn
b. 5 May 1932 d. 30 Mar 1997
9
Julia Daggett
[1.1.1.1.4.3.1.1.3]
b. 28 May 1837 d. 22 Apr 1921
Sidney A Crosby
b. 1831 d. 15 Sep 1901
10
Elery Adelbert Crosby
[1.1.1.1.4.3.1.1.3.1]
b. 11 Dec 1858 d. 20 Nov 1943
Lucy Amelia Powers
b. 24 Sep 1863 d. 5 Jul 1934
11
George Henry Crosby
[1.1.1.1.4.3.1.1.3.1.1]
b. 4 Apr 1882 d. 9 Dec 1971
Grace V Hunter
b. 11 Jul 1881 d. 28 Mar 1955
12
Margaret Lucy Crosby
[1.1.1.1.4.3.1.1.3.1.1.1]
b. 22 Jul 1902 d. 20 Dec 1987
12
Edgar J Crosby
[1.1.1.1.4.3.1.1.3.1.1.2]
b. 31 Oct 1903 d. 16 Mar 1983
12
Hunter B Crosby
[1.1.1.1.4.3.1.1.3.1.1.3]
b. 9 Mar 1906 d. 15 Sep 1988
12
Paul Adelbert Crosby
[1.1.1.1.4.3.1.1.3.1.1.4]
b. 6 Oct 1908 d. 15 Aug 1977
12
Rosina Crosby
[1.1.1.1.4.3.1.1.3.1.1.5]
b. 1911 d. 30 Oct 1936
12
David L Crosby
[1.1.1.1.4.3.1.1.3.1.1.6]
b. 30 Mar 1913 d. 6 Nov 1998
11
Mainard Elery Crosby
[1.1.1.1.4.3.1.1.3.1.2]
b. 26 Sep 1884 d. 19 Jun 1976
Cora May Berkey
b. 16 Jun 1883 d. 2 Apr 1964
12
Robert Berkey Crosby
[1.1.1.1.4.3.1.1.3.1.2.1]
b. 26 Mar 1911 d. 7 Jan 2000
12
Lucy Anne Crosby
[1.1.1.1.4.3.1.1.3.1.2.2]
b. 1 Nov 1923 d. 5 Apr 1997
11
Elmer Adelbert Crosby
[1.1.1.1.4.3.1.1.3.1.3]
b. 23 Jul 1887 d. 27 Nov 1979
Lillie Estella Grimshaw
b. 12 Feb 1889 d. 16 Aug 1970
12
Eleanor Roberta Crosby
[1.1.1.1.4.3.1.1.3.1.3.1]
b. 25 Mar 1914 d. 14 Aug 1995
11
Mary Belle Crosby
[1.1.1.1.4.3.1.1.3.1.4]
b. 18 Mar 1891 d. 19 Mar 1944
Eben David Warner
b. 28 Nov 1881 d. 2 Apr 1960
12
Zua Gae Warner
[1.1.1.1.4.3.1.1.3.1.4.1]
b. 18 May 1914 d. 6 Feb 1997
12
Eben David Warner, Jr
[1.1.1.1.4.3.1.1.3.1.4.2]
b. 15 Jun 1917 d. 27 Jun 2002 [
=>
]
10
Carrie Bell Crosby
[1.1.1.1.4.3.1.1.3.2]
b. 1861 d. 5 Nov 1932
Will N Garrett
b. 6 Jan 1854 d. 1 Dec 1926
11
Emma Garrett
[1.1.1.1.4.3.1.1.3.2.1]
b. 20 Jun 1881 d. 3 Feb 1916
11
Thomas Garrett
[1.1.1.1.4.3.1.1.3.2.2]
b. Mar 1882
11
Julia Garrett
[1.1.1.1.4.3.1.1.3.2.3]
b. Jul 1884
10
Laura Elizabeth Crosby
[1.1.1.1.4.3.1.1.3.3]
b. 2 Nov 1863 d. 18 Nov 1934
Henry Franklin Garrett
b. 4 Jun 1858 d. 8 Aug 1919
11
Dorothy Garrett
[1.1.1.1.4.3.1.1.3.3.1]
b. 1 Apr 1881 d. 1 Nov 1960
George A Hoppock
b. 4 Apr 1868 d. 3 Mar 1935
12
Frank C Hoppock
[1.1.1.1.4.3.1.1.3.3.1.1]
b. 28 Jan 1905 d. 18 Nov 1984 [
=>
]
12
Howard W Hoppock
[1.1.1.1.4.3.1.1.3.3.1.2]
b. 1912 d. 26 Feb 1933
11
Adelbert D Garrett
[1.1.1.1.4.3.1.1.3.3.2]
b. Sep 1890
11
Nellie M Garrett
[1.1.1.1.4.3.1.1.3.3.3]
b. Oct 1892
11
William Wallace Garrett
[1.1.1.1.4.3.1.1.3.3.4]
b. Jun 1894
11
Benjamin T Garrett
[1.1.1.1.4.3.1.1.3.3.5]
b. Jul 1897
11
Mark Hanna Garrett
[1.1.1.1.4.3.1.1.3.3.6]
b. Feb 1900
10
Henry Foster Crosby
[1.1.1.1.4.3.1.1.3.4]
b. 18 May 1868 d. 21 Jan 1958
Theresa Mary Gerwein
b. 9 Feb 1870 d. Abt 1930
11
Martin Edward Crosby
[1.1.1.1.4.3.1.1.3.4.1]
b. 31 Oct 1895 d. 23 Oct 1990
11
Mary Frances Crosby
[1.1.1.1.4.3.1.1.3.4.2]
b. 6 Oct 1897
+
Charles Birney Sowles
b. 19 Jan 1893 d. Bef 1930
11
Lydia Crosby
[1.1.1.1.4.3.1.1.3.4.3]
b. Mar 1900
11
Alma Bertha Crosby
[1.1.1.1.4.3.1.1.3.4.4]
b. Abt 1902
+
Walter Amos Wood
b. 18 Feb 1893
11
Delbert E Crosby
[1.1.1.1.4.3.1.1.3.4.5]
b. 1903
11
Clifford Crosby
[1.1.1.1.4.3.1.1.3.4.6]
b. 11 Nov 1907 d. 20 May 1986
10
George Marshal Crosby
[1.1.1.1.4.3.1.1.3.5]
b. 27 Oct 1870 d. 16 Dec 1922
+
Eva George
b. Abt 1883
10
Mary Crosby
[1.1.1.1.4.3.1.1.3.6]
b. 1879 d. 1879
9
Elisha S Daggett
[1.1.1.1.4.3.1.1.4]
b. 1839
9
Electa Elizabeth Daggett
[1.1.1.1.4.3.1.1.5]
b. Sep 1844
Delos D Stetson
b. 1837 d. 10 Jul 1884
10
Florence Stetson
[1.1.1.1.4.3.1.1.5.1]
b. Mar 1870
10
Alvin Stetson
[1.1.1.1.4.3.1.1.5.2]
b. 1872
10
Georgia Stetson
[1.1.1.1.4.3.1.1.5.3]
b. 9 Mar 1875 d. Sep 1949
Henry LaBrash
b. 1856
11
Robert George LaBrash
[1.1.1.1.4.3.1.1.5.3.1]
b. 11 Feb 1905 d. 5 Mar 1955
+
Viola Elvera Olson
b. 21 Jan 1905 d. 12 Jun 1990
+
Henry J Porter
b. Jan 1840 d. 6 Apr 1918
9
Mary Louisa Daggett
[1.1.1.1.4.3.1.1.6]
b. 1847
Marshall Lee Daggett
b. 12 Jan 1848
10
Robert Daggett
[1.1.1.1.4.3.1.1.6.1]
b. 11 Nov 1869
10
Son Daggett
[1.1.1.1.4.3.1.1.6.2]
b. 17 Nov 1869
10
Blanch Daggett
[1.1.1.1.4.3.1.1.6.3]
b. 10 Aug 1874 d. 9 Mar 1880
10
Myron Daggett
[1.1.1.1.4.3.1.1.6.4]
b. 14 Jul 1886 d. 13 May 1887
7
Anna Daggett
[1.1.1.1.4.3.2]
b. 11 Sep 1762 d. Aft 1788
William Estey
b. 9 Aug 1759 d. 1843
8
Nabby Estey
[1.1.1.1.4.3.2.1]
b. 8 Jul 1791
8
Fanny Estey
[1.1.1.1.4.3.2.2]
b. 28 Mar 1793
8
Betsey Estey
[1.1.1.1.4.3.2.3]
b. 26 Apr 1795
8
Anna Estey
[1.1.1.1.4.3.2.4]
b. 25 Aug 1797
8
Gilman Estey
[1.1.1.1.4.3.2.5]
b. 14 Oct 1799 d. 14 Oct 1877
+
Louisa Thompson
b. 29 Apr 1819 d. 22 Feb 1885
8
Caroline Estey
[1.1.1.1.4.3.2.6]
b. 27 Dec 1801
+
George Rice
b. 1807
7
Phineas Daggett
[1.1.1.1.4.3.3]
b. 22 Aug 1764
Betsey Wilson
b. 1769 d. 11 Aug 1791
8
William Daggett
[1.1.1.1.4.3.3.1]
b. 21 Dec 1788 d. 2 Jun 1818
Clarissa Wait
b. 1791 d. 1862
9
William Daggett
[1.1.1.1.4.3.3.1.1]
b. 1813 d. 16 May 1860
9
Clarissa Daggett
[1.1.1.1.4.3.3.1.2]
b. 6 Mar 1815 d. 10 Nov 1890
Sidney Smith Campbell
b. 3 Mar 1810 d. 26 Feb 1896
10
Mary Elizabeth Campbell
[1.1.1.1.4.3.3.1.2.1]
b. 28 Aug 1836 d. 16 Mar 1871
10
Charles Sidney Campbell
[1.1.1.1.4.3.3.1.2.2]
b. Abt 1838
10
Clara Anna Campbell
[1.1.1.1.4.3.3.1.2.3]
b. Abt 1840
9
George Wait Daggett
[1.1.1.1.4.3.3.1.3]
b. 30 Jun 1818 d. 25 Jun 1884
Sarah Lauretta Cole
b. 7 Mar 1821
10
George Marshall Daggett
[1.1.1.1.4.3.3.1.3.1]
b. 16 Oct 1848 d. 11 Jul 1862
10
Sarah Louise Daggett
[1.1.1.1.4.3.3.1.3.2]
b. 19 May 1850 d. 23 Dec 1881
Thomas Smith Merrill
b. 8 Sep 1836 d. 28 Dec 1909
11
Maud Evylin Merrill
[1.1.1.1.4.3.3.1.3.2.1]
b. 26 Mar 1873
11
Blanche Auretta Merrill
[1.1.1.1.4.3.3.1.3.2.2]
b. 12 Oct 1875
DuFay Alonzo Fuller
b. 21 Feb 1852 d. 3 Mar 1924
12
Louise Blanche Fuller
[1.1.1.1.4.3.3.1.3.2.2.1]
b. 6 Jun 1903
10
Clara Esther Daggett
[1.1.1.1.4.3.3.1.3.3]
b. 3 Mar 1852
William Graves Leonard
b. 3 Feb 1853 d. 5 Apr 1933
11
Wallace Cole Leonard
[1.1.1.1.4.3.3.1.3.3.1]
b. 20 Mar 1877
11
Eva louise Leonard
[1.1.1.1.4.3.3.1.3.3.2]
b. 25 Jun 1879 d. 21 Mar 1889
10
Walter Sidney Daggett
[1.1.1.1.4.3.3.1.3.4]
b. 1855 d. 31 Mar 1901
Flora Lucinda Evans
b. 21 Jul 1861 d. 14 Jun 1954
11
Lewis E Daggett
[1.1.1.1.4.3.3.1.3.4.1]
b. 21 Aug 1895 d. May 1979
11
Frank Heber Daggett
[1.1.1.1.4.3.3.1.3.4.2]
b. 31 Aug 1896 d. 2 Nov 1981
11
Walter S Daggett
[1.1.1.1.4.3.3.1.3.4.3]
b. 1901
+
Cecilia Agnes Crowley
b. 1898 d. 1972
10
Eliza Elizabeth "Lillie Bell" Daggett
[1.1.1.1.4.3.3.1.3.5]
b. 30 Jun 1857 d. 22 Jul 1862
9
Eliza Daggett
[1.1.1.1.4.3.3.1.4]
b. 2 Oct 1817
Stephen Kimball Cutter
b. 12 Mar 1815
10
Frances Eveline Cutter
[1.1.1.1.4.3.3.1.4.1]
b. 28 Apr 1839 d. 14 Sep 1859
+
Veranis Bemis Coleman
b. 21 Jan 1837
10
Judson Charles Cutter
[1.1.1.1.4.3.3.1.4.2]
b. 30 Jul 1842
10
Addison Adolphus Cutter
[1.1.1.1.4.3.3.1.4.3]
b. 20 Apr 1845 d. 26 Jun 1845
10
Addison Adolphus Cutter
[1.1.1.1.4.3.3.1.4.4]
b. 5 Oct 1846 d. 7 Jul 1906
Arabella Mathilda "Bella" Flanders
b. 1852 d. 17 May 1943
11
Elizabeth Cutter
[1.1.1.1.4.3.3.1.4.4.1]
b. 1879 d. 16 Feb 1884
11
Louise C Cutter
[1.1.1.1.4.3.3.1.4.4.2]
b. 1885 d. Nov 1971
11
Helen Catharine Cutter
[1.1.1.1.4.3.3.1.4.4.3]
b. 17 Jan 1887 d. 24 Apr 1974
Steven Roger Davis
b. 1884
12
Addison Cutter Davis
[1.1.1.1.4.3.3.1.4.4.3.1]
b. 27 Jul 1917 d. 26 Nov 1983
10
Ella Eliza Cutter
[1.1.1.1.4.3.3.1.4.5]
b. 30 Mar 1849
8
Artemas Daggett
[1.1.1.1.4.3.3.2]
b. 17 Jul 1790 d. 1835
Sally Smith
b. Abt 1792
9
Daughter Daggett
[1.1.1.1.4.3.3.2.1]
b. Abt 1806
9
Daughter Daggett
[1.1.1.1.4.3.3.2.2]
b. Abt 1808
9
Daughter Daggett
[1.1.1.1.4.3.3.2.3]
b. Abt 1810
Marcy Pierce
b. 6 Aug 1771 d. 29 Jun 1850
8
Polly Daggett
[1.1.1.1.4.3.3.3]
b. 6 Aug 1795 d. 6 Aug 1802
8
Hiram Daggett
[1.1.1.1.4.3.3.4]
b. 9 Aug 1797 d. 1 Jan 1832
8
Betsey Dagget
[1.1.1.1.4.3.3.5]
b. 31 Dec 1799 d. 1877
Broughton Knight
b. 25 Feb 1798 d. 4 Feb 1854
9
Allona B Knight
[1.1.1.1.4.3.3.5.1]
b. Abt 1833 d. 17 Dec 1869
9
Phila Knight
[1.1.1.1.4.3.3.5.2]
b. Apr 1836
9
George P Knight
[1.1.1.1.4.3.3.5.3]
b. Aug 1840
8
Hollis Daggett
[1.1.1.1.4.3.3.6]
b. 4 Nov 1802 d. 1882
Flora Jackman
b. Abt 1806
9
Frederick Daggett
[1.1.1.1.4.3.3.6.1]
b. Abt 1826
9
Daughter Daggett
[1.1.1.1.4.3.3.6.2]
b. Abt 1828
8
Lewis Daggett
[1.1.1.1.4.3.3.7]
b. 15 Aug 1804
Harriet Haughton
b. 7 Aug 1807 d. 10 Aug 1866
9
Hiram Sibley Daggett
[1.1.1.1.4.3.3.7.1]
b. 3 Feb 1833 d. 25 Nov 1861
9
Carolina Louisa Daggett
[1.1.1.1.4.3.3.7.2]
b. 7 Jun 1837 d. 14 Feb 1339
9
Henry Talmadge Daggett
[1.1.1.1.4.3.3.7.3]
b. 8 Feb 1840
Mary Eaton
b. 27 Jun 1840 d. 28 Apr 1884
10
Frankie Daggett
[1.1.1.1.4.3.3.7.3.1]
b. 8 Jun 1869 d. 3 Sep 1869
10
William L Daggett
[1.1.1.1.4.3.3.7.3.2]
b. 1 Aug 1871
10
Mary Harriet Daggett
[1.1.1.1.4.3.3.7.3.3]
b. 5 Mar 1884
9
Charles Prentice Daggett
[1.1.1.1.4.3.3.7.4]
b. 5 Oct 1843 d. 14 Jan 1846
9
Charles Lewis Daggett
[1.1.1.1.4.3.3.7.5]
b. 14 Jan 1851 d. 25 Feb 1869
8
Prentis Daggett
[1.1.1.1.4.3.3.8]
b. 25 Aug 1807 d. 29 Oct 1881
8
Mary Daggett
[1.1.1.1.4.3.3.9]
b. 1809 d. 1841
Daniel Pierce
b. 1808
9
Darwin Pierce
[1.1.1.1.4.3.3.9.1]
b. Abt 1836
9
Horace Pierce
[1.1.1.1.4.3.3.9.2]
b. Abt 1838
8
Louisa Daggett
[1.1.1.1.4.3.3.10]
b. 10 Dec 1812
Moses Knapp Pratt
b. 1 Jan 1813 d. 15 Mar 1884
9
Frederic Knight Pratt
[1.1.1.1.4.3.3.10.1]
b. 25 May 1843
Marion B Turnure
b. 1854
10
Frank Hollis Pratt
[1.1.1.1.4.3.3.10.1.1]
b. 25 Nov 1877
10
Ralph Turnure Pratt
[1.1.1.1.4.3.3.10.1.2]
b. 22 Apr 1884
7
Nathaniel Daggett
[1.1.1.1.4.3.4]
b. 1766 d. 16 Jun 1852
Electa Roberts
b. 12 Dec 1771 d. 27 Oct 1856
8
Harry Daggett
[1.1.1.1.4.3.4.1]
b. 1793 d. 14 Nov 1869
Julia Crane
b. 1797 d. 25 Dec 1890
9
Julia Ann Daggett
[1.1.1.1.4.3.4.1.1]
b. 29 Jul 1820
9
Harry Crane Daggett
[1.1.1.1.4.3.4.1.2]
b. 24 Dec 1821
Nancy D Whitcomb
b. 2 Oct 1833 d. 28 Nov 1906
10
Milton H Daggett
[1.1.1.1.4.3.4.1.2.1]
b. Mar 1858 d. 1935
Asenath Sprague Voter
b. 15 Aug 1865 d. 11 Jan 1954
11
Earle Voter Daggett
[1.1.1.1.4.3.4.1.2.1.1]
b. 20 Apr 1888
+
Edith L Swann
b. 1890
11
Harry Clarence Daggett
[1.1.1.1.4.3.4.1.2.1.2]
b. 7 Apr 1893 d. Jan 1971
Nancy
12
Emma J Daggett
[1.1.1.1.4.3.4.1.2.1.2.1]
b. 1855
12
Milton H Daggett
[1.1.1.1.4.3.4.1.2.1.2.2]
b. 1856
11
Mildred Maude Daggett
[1.1.1.1.4.3.4.1.2.1.3]
b. 11 Sep 1895 d. 16 Dec 1990
9
Royal Montraville Daggett
[1.1.1.1.4.3.4.1.3]
b. 9 Sep 1823
Adeline L Weeden
b. 25 Jul 1824
10
Emera Montraville Daggett
[1.1.1.1.4.3.4.1.3.1]
b. 1853 d. 1926
Dora A Herrick
b. 16 Nov 1857 d. 3 Dec 1908
11
Alfred E Daggett
[1.1.1.1.4.3.4.1.3.1.1]
b. 31 Aug 1879 d. 19 Jul 1965
11
Bernice Julia Daggett
[1.1.1.1.4.3.4.1.3.1.2]
b. 17 May 1895 d. 11 Mar 1977
9
Carlos Manson Daggett
[1.1.1.1.4.3.4.1.4]
b. 1 Mar 1827
9
Oscar Fitzwilliam Daggett
[1.1.1.1.4.3.4.1.5]
b. 11 May 1833 d. Aft 1880
Mary Dillocy Brooks
b. 8 Mar 1840 d. Aft 1863
10
Ida M Daggett
[1.1.1.1.4.3.4.1.5.1]
b. 1866
8
Shubael Daggett
[1.1.1.1.4.3.4.2]
b. 1797
8
Orville Daggett
[1.1.1.1.4.3.4.3]
b. 1799
8
Celista Daggett
[1.1.1.1.4.3.4.4]
b. 1801 d. 6 Jan 1862
8
Phineas Daggett
[1.1.1.1.4.3.4.5]
b. 1802
8
Phinehas Daggett
[1.1.1.1.4.3.4.6]
b. 9 Aug 1802 d. 30 Oct 1877
Emeline Boynton
b. 29 Jul 1807 d. 6 Feb 1881
9
Pemelia Anne Daggett
[1.1.1.1.4.3.4.6.1]
b. 17 Apr 1829 d. 5 Jul 1883
9
Hallis Boynton Daggett
[1.1.1.1.4.3.4.6.2]
b. 28 Dec 1830 d. 14 Feb 1835
9
Lillian Sarah Daggett
[1.1.1.1.4.3.4.6.3]
b. 3 Dec 1832 d. 20 Oct 1861
George James
b. 3 Apr 1827 d. 22 May 1902
10
Ellen Eudora James
[1.1.1.1.4.3.4.6.3.1]
b. 5 May 1851 d. 28 Jan 1908
10
Myra Louisa James
[1.1.1.1.4.3.4.6.3.2]
b. 5 Oct 1852 d. 15 Jul 1926
Robert Blum Reinhardt
b. 14 Jan 1849 d. 29 Dec 1929
11
Robert Reinhardt
[1.1.1.1.4.3.4.6.3.2.1]
b. Abt 1873
11
Lillian Sarah Reinhardt
[1.1.1.1.4.3.4.6.3.2.2]
b. 29 Oct 1874 d. 1 Dec 1954
Jose Rollin de La Torre Bueno
b. 6 Oct 1871 d. 3 May 1948
12
Lillian Mary de La Torre Bueno
[1.1.1.1.4.3.4.6.3.2.2.1]
b. 15 Mar 1902 d. 13 Sep 1993
12
Jose Rollin de La Torre Bueno
[1.1.1.1.4.3.4.6.3.2.2.2]
b. 4 Apr 1904 d. 15 Jan 1980
12
Elena Dorothy de La Torre Bueno
[1.1.1.1.4.3.4.6.3.2.2.3]
b. 5 Jan 1905 d. 20 Nov 1905
12
Myra Rose de La Torre Bueno
[1.1.1.1.4.3.4.6.3.2.2.4]
b. 20 Feb 1908 d. 23 Feb 1990 [
=>
]
12
Robert Reinhardt de La Torre Bueno
[1.1.1.1.4.3.4.6.3.2.2.5]
b. 22 Aug 1910 d. Jan 1911
12
Theodore Robert de La Torre Bueno
[1.1.1.1.4.3.4.6.3.2.2.6]
b. 1 Dec 1914 d. 1991
12
Richard Thorne de La Torre Bueno
[1.1.1.1.4.3.4.6.3.2.2.7]
b. 6 Aug 1917 d. 9 Sep 1987
12
Helen Barbara de La Torre Bueno
[1.1.1.1.4.3.4.6.3.2.2.8]
b. 9 Feb 1921 d. May 1998
11
George Frederick Reinhardt
[1.1.1.1.4.3.4.6.3.2.3]
b. 2 Jan 1877 d. 25 Jun 1931
Anna Lilian Douglas
b. 24 Apr 1884 d. 5 Feb 1961
12
Phyllis Anna Reinhardt
[1.1.1.1.4.3.4.6.3.2.3.1]
b. 7 May 1913 d. 1969
10
Sarah Lillian James
[1.1.1.1.4.3.4.6.3.3]
b. 31 Jan 1856 d. 1921
9
May Miriah Daggett
[1.1.1.1.4.3.4.6.4]
b. 10 Feb 1836
9
Mary M Daggett
[1.1.1.1.4.3.4.6.5]
b. 10 Feb 1836
9
Harriet B Daggett
[1.1.1.1.4.3.4.6.6]
b. 11 Sep 1837
9
Joseph Nathaniel Daggett
[1.1.1.1.4.3.4.6.7]
b. 17 Nov 1839 d. 24 Mar 1902
9
Emeline Arethusa Daggett
[1.1.1.1.4.3.4.6.8]
b. 25 Sep 1841 d. 15 Oct 1910
George James
b. 3 Apr 1827 d. 22 May 1902
10
Rosa Beatrice James
[1.1.1.1.4.3.4.6.8.1]
b. 29 May 1866
Charles Robert Piper
b. 25 May 1862
11
Harold Raymond Piper
[1.1.1.1.4.3.4.6.8.1.1]
b. 15 Apr 1892 d. 28 Apr 1914
11
Majorie Boynton Piper
[1.1.1.1.4.3.4.6.8.1.2]
b. 19 Apr 1897 d. 10 Mar 1987
Clarence Weldon Evaul
b. 1 Jul 1897 d. May 1986
12
Robert Weldon Evaul
[1.1.1.1.4.3.4.6.8.1.2.1]
b. 16 Dec 1922 d. 16 Mar 2006
+
William Preston Palmer
b. 19 Apr 1892 d. 16 Oct 1989
10
Edward James
[1.1.1.1.4.3.4.6.8.2]
b. 1871 d. 1875
9
Loretta Lamar Daggett
[1.1.1.1.4.3.4.6.9]
b. 27 May 1844
9
Ellen Daggett
[1.1.1.1.4.3.4.6.10]
b. 1 Nov 1846
9
Abbie Daggett
[1.1.1.1.4.3.4.6.11]
b. 17 Apr 1848
8
Nathaniel Daggett, Jr
[1.1.1.1.4.3.4.7]
b. 1804
8
Alpheus Daggett
[1.1.1.1.4.3.4.8]
b. 1807
8
Samuel Daggett
[1.1.1.1.4.3.4.9]
b. 1810
8
Philarmon Daggett
[1.1.1.1.4.3.4.10]
b. 1812
8
Amos Daggett
[1.1.1.1.4.3.4.11]
b. 1814
8
Electa Daggett
[1.1.1.1.4.3.4.12]
b. 1816
7
Susan Daggett
[1.1.1.1.4.3.5]
b. Abt 1768
John Rice
b. 1764 d. 1841
8
Nancy Rice
[1.1.1.1.4.3.5.1]
b. 1789
+
Luther Denison
b. Abt 1787
+
Jeremiah Robbins
b. Abt 1785
8
John Rice
[1.1.1.1.4.3.5.2]
b. 1791 d. Aft 1824
Eliza Burke
b. 29 May 1797
9
Ebed Burke Rice
[1.1.1.1.4.3.5.2.1]
b. Abt 1824
8
Mary "Polly" Rice
[1.1.1.1.4.3.5.3]
b. 1793 d. 1854
Samuel Nichols
b. 1772
9
Caroline E Nichols
[1.1.1.1.4.3.5.3.1]
b. 1818 d. 3 Aug 1903
William Storer
b. 1817
10
Ellen Maria Storer
[1.1.1.1.4.3.5.3.1.1]
b. 2 Jun 1847 d. 22 Nov 1896
10
Eliza M Storer
[1.1.1.1.4.3.5.3.1.2]
b. 20 Jun 1847 d. Bef 1855
10
William Nichols Storer
[1.1.1.1.4.3.5.3.1.3]
b. 16 Sep 1849 d. 7 Jun 1909
Emma Frances Chesley
b. 11 Apr 1853
11
Eliot Chesley Storer
[1.1.1.1.4.3.5.3.1.3.1]
b. 7 Oct 1887
+
Florence May Woodward
b. 6 Jan 1890
11
Paul Nichols Storer
[1.1.1.1.4.3.5.3.1.3.2]
b. 8 Nov 1891
10
Henry Johnson Storer
[1.1.1.1.4.3.5.3.1.4]
b. 28 Aug 1860 d. 1 May 1935
+
Bernice Lavina Georgiana Olive
b. 7 Apr 1872 d. Bef 1990
8
Lewis Rice
[1.1.1.1.4.3.5.4]
b. 1796 d. 1835
8
Louisa Rice
[1.1.1.1.4.3.5.5]
b. 1798
+
Gilman Esty
8
Fannie Rice
[1.1.1.1.4.3.5.6]
b. 1800 d. Aft 1821
Tyler Curtis Knight
b. 23 Aug 1797 d. 22 Apr 1855
9
Lucretia Knight
[1.1.1.1.4.3.5.6.1]
d. 22 Apr 1855
+
Charles A Towne
8
Lucinda Rice
[1.1.1.1.4.3.5.7]
b. 1802
+
John Bryant
b. Abt 1800
8
Horace Rice
[1.1.1.1.4.3.5.8]
b. 1804
8
Emily Rice
[1.1.1.1.4.3.5.9]
b. 1809
+
Thurman Richardson
b. Abt 1805
8
Susan Rice
[1.1.1.1.4.3.5.10]
b. 1811
+
Calvin B Meade
b. Abt 1807
8
George Rice
[1.1.1.1.4.3.5.11]
b. 1807
+
Caroline Estey
b. 27 Dec 1801
7
Hannah Daggett
[1.1.1.1.4.3.6]
b. 1770
+
Horton
7
Sarah Daggett
[1.1.1.1.4.3.7]
b. Abt 1772
7
Amos Daggett
[1.1.1.1.4.3.8]
b. Abt 1772
7
Daughter Daggett
[1.1.1.1.4.3.9]
b. Abt 1774
+
William Ide
6
Arthur Daggett
[1.1.1.1.4.4]
b. 30 Jan 1730 d. 23 Aug 1775
Mehitable King
b. 8 May 1731 d. 13 Mar 1809
7
Arthur Daggett, Jr
[1.1.1.1.4.4.1]
b. 23 Apr 1751 d. 25 Aug 1835
Lucy Cutler
b. 17 Apr 1749 d. 23 Feb 1813
8
Arthur Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.1]
b. 13 Sep 1774 d. 11 Jan 1855
Azuba Haskell
b. 8 Mar 1768
9
Arthur Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.1.1]
b. 4 Apr 1803
9
Freeman Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.1.2]
b. 20 Jun 1807
Calista Ingalls
b. 9 Jan 1809 d. 30 Aug 1886
10
George Dagget
[1.1.1.1.4.4.1.1.2.1]
b. 18 Sep 1835 d. 1885
+
Sarah Emeline Hamblin
b. 12 Nov 1839 d. Aft 1863
8
Stephen Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.2]
b. 7 Mar 1776 d. 22 Dec 1810
Mary Doty
b. 13 Aug 1781 d. 15 Mar 1855
9
Lucy Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.2.1]
b. 28 Jan 1805
Alphena Bliss
b. 13 Nov 1802 d. 1 Feb 1844
10
Catharine Amelia Bliss
[1.1.1.1.4.4.1.2.1.1]
b. 31 Aug 1828 d. 12 Feb 1892
John Van Ransselaer Kent
b. 21 Nov 1813 d. 12 Feb 1892
11
Charles Van Kent
[1.1.1.1.4.4.1.2.1.1.1]
b. 19 Dec 1857 d. 19 Dec 1945
+
Mary Myrtella Peck
b. 15 Jun 1862
+
Orlando Morse
b. 21 Aug 1817 d. 14 Jun 1852
10
Caroline Elizabeth Bliss
[1.1.1.1.4.4.1.2.1.2]
b. 10 Sep 1840
William Commins Robinson
b. 9 Jun 1838
11
Ida Lucy Robinson
[1.1.1.1.4.4.1.2.1.2.1]
b. 19 Apr 1868
9
Catharine Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.2.2]
b. 16 Jan 1807 bur. 1887
Levi Robinson
b. 18 Sep 1803 d. 7 Sep 1863
10
Joel Emery Robinson
[1.1.1.1.4.4.1.2.2.1]
b. 18 Feb 1834 d. 28 Jul 1863
10
Julius Robinson
[1.1.1.1.4.4.1.2.2.2]
b. 9 Mar 1836
Mary Amelia Pierce
b. 31 May 1840 d. 11 Sep 1872
11
Irvin George Robinson
[1.1.1.1.4.4.1.2.2.2.1]
b. 22 Jan 1864 d. 13 Dec 1941
Minnie R Swasey
b. 10 Feb 1864
12
Minnie Swasey Robinson
[1.1.1.1.4.4.1.2.2.2.1.1]
b. 19 Nov 1888
12
Mary Louise Robinson
[1.1.1.1.4.4.1.2.2.2.1.2]
b. 7 Apr 1893
12
Mildred Amanda Robinson
[1.1.1.1.4.4.1.2.2.2.1.3]
b. 6 May 1895
12
Emily Laura Robinson
[1.1.1.1.4.4.1.2.2.2.1.4]
b. 25 Nov 1897 d. 1 Sep 1925
12
Ilda Margaret Robinson
[1.1.1.1.4.4.1.2.2.2.1.5]
b. 30 Nov 1902
11
Ilda Guella Robinson
[1.1.1.1.4.4.1.2.2.2.2]
b. 6 Dec 1865
11
Inda M Robinson
[1.1.1.1.4.4.1.2.2.2.3]
b. 13 Apr 1867 d. 1929
Simon Shubael Wheeler
b. 25 May 1865 d. 1947
12
Julius Henry Wheeler
[1.1.1.1.4.4.1.2.2.2.3.1]
b. 18 Aug 1890 d. Abt 1965
12
Joel Robinson Wheeler
[1.1.1.1.4.4.1.2.2.2.3.2]
b. 5 Oct 1893 d. 6 Jun 1982
12
Raymond Dewey Wheeler
[1.1.1.1.4.4.1.2.2.2.3.3]
b. 24 Jun 1898 d. 21 Oct 1981 [
=>
]
11
Lucy C Robinson
[1.1.1.1.4.4.1.2.2.2.4]
b. 1868
10
Otis Vinton Robinson
[1.1.1.1.4.4.1.2.2.3]
b. 25 Jul 1838 d. 15 Sep 1863
10
Mary Cherville Robinson
[1.1.1.1.4.4.1.2.2.4]
b. 24 Aug 1845 d. 28 Nov 1922
James Kelton Toby
b. 17 Jun 1845 d. 21 Apr 1883
11
Celia Mary Tobey
[1.1.1.1.4.4.1.2.2.4.1]
b. 7 Oct 1873
11
Lelia M Toby
[1.1.1.1.4.4.1.2.2.4.2]
b. 7 Oct 1876
11
Catherine Laura Tobey
[1.1.1.1.4.4.1.2.2.4.3]
b. 8 Oct 1879
Ira Richardson
b. 23 May 1869
12
Elizabeth F Richardson
[1.1.1.1.4.4.1.2.2.4.3.1]
b. 1903
9
James Sullivan Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.2.3]
b. 20 Sep 1808
+
Elisabeth Vinton
b. Jul 1812 d. 12 Jun 1850
Fidelia Pratt
b. 1818
10
Abbie Elizabeth Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.2.3.1]
b. 22 Sep 1851
+
William Henshaw Daley
d. 4 Nov 1904
9
Marietta Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.2.4]
b. 9 Sep 1809 d. 26 Oct 1840
8
John Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3]
b. 22 Dec 1777 d. 26 Aug 1820
Loruhanah Nealy
b. 5 Aug 1782 d. 1814
9
Nealy Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.1]
b. 17 Apr 1803 d. 24 Aug 1824
9
Katherine Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.2]
b. 16 Jan 1807 d. 1887
Ebenezer Chapin
b. 1 May 1800 d. 29 Jan 1874
10
Nealy Adolphus Chapin
[1.1.1.1.4.4.1.3.2.1]
b. 28 Jan 1828 d. 30 Mar 1899
Cordelia Olive Perry
b. 29 Jul 1829
11
William Adolphus Chapin
[1.1.1.1.4.4.1.3.2.1.1]
b. 31 Oct 1852 d. 4 Sep 1868
11
Eben Hubert Chapin
[1.1.1.1.4.4.1.3.2.1.2]
b. 21 Nov 1854 d. 8 Feb 1909
Kate Anne Mathews
b. 5 Jun 1861 d. 18 Oct 1883
12
Charles Mathews Chapin
[1.1.1.1.4.4.1.3.2.1.2.1]
b. 19 Sep 1884
12
Elsa Chapin
[1.1.1.1.4.4.1.3.2.1.2.2]
b. 28 May 1886
12
Ruth Chapin
[1.1.1.1.4.4.1.3.2.1.2.3]
b. 20 Sep 1887 d. 28 Feb 1905
12
Nealy A Chapin
[1.1.1.1.4.4.1.3.2.1.2.4]
b. 30 Aug 1899 d. Aug 1977
12
Son Chapin
[1.1.1.1.4.4.1.3.2.1.2.5]
b. Abt 1901
11
Florence Chapin
[1.1.1.1.4.4.1.3.2.1.3]
b. 9 Dec 1856 d. 18 May 1931
George W Ellis
b. 30 Dec 1846 d. 30 Oct 1888
12
Nealy Peres Ellis
[1.1.1.1.4.4.1.3.2.1.3.1]
b. 15 Mar 1882
12
Glen James Ellis
[1.1.1.1.4.4.1.3.2.1.3.2]
b. 5 Dec 1885 d. 13 Oct 1945
12
John Robert "Bert" Ellis
[1.1.1.1.4.4.1.3.2.1.3.3]
b. 8 Nov 1887 d. 9 Jul 1971
William Hetman Hartwell
b. 31 Aug 1844 d. 27 May 1924
12
Marian Lila Hartwell
[1.1.1.1.4.4.1.3.2.1.3.4]
b. 23 Sep 1892
12
Sarah Ruth Hartwell
[1.1.1.1.4.4.1.3.2.1.3.5]
b. 28 Mar 1896 d. 10 Apr 1995
11
Kate Bertha Chapin
[1.1.1.1.4.4.1.3.2.1.4]
b. 9 Sep 1859 d. 27 Nov 1949
James Franklin Morgan
b. 1 Dec 1852 d. 11 Mar 1931
12
Bessie Morgan
[1.1.1.1.4.4.1.3.2.1.4.1]
b. 16 Jul 1880 d. 12 May 1977
12
Olive Morgan
[1.1.1.1.4.4.1.3.2.1.4.2]
b. Abt 1882 d. Bef 1884
12
Olive Myrtle Morgan
[1.1.1.1.4.4.1.3.2.1.4.3]
b. 12 Feb 1884 d. 14 May 1979 [
=>
]
11
Frederick Lincoln Chapin
[1.1.1.1.4.4.1.3.2.1.5]
b. 16 Jun 1863 d. 19 Dec 1913
Grace Card Selden
b. 17 Oct 1864
12
Lydia Seldon Chapin
[1.1.1.1.4.4.1.3.2.1.5.1]
b. 19 Sep 1896
12
Seldon Chapin
[1.1.1.1.4.4.1.3.2.1.5.2]
b. 19 Sep 1899
11
Jennie Mary Chapin
[1.1.1.1.4.4.1.3.2.1.6]
b. 11 Dec 1865 d. 15 Sep 1936
John Magaw Glenn
b. 14 Nov 1859 d. 22 Apr 1928
12
Mary Chapin Glenn
[1.1.1.1.4.4.1.3.2.1.6.1]
b. 5 Jul 1889
12
Helen Elizabeth Glenn
[1.1.1.1.4.4.1.3.2.1.6.2]
b. 9 Jun 1891
12
John Jay Glenn
[1.1.1.1.4.4.1.3.2.1.6.3]
b. 17 Dec 1893 d. 11 Nov 1979
12
Robert Glenn
[1.1.1.1.4.4.1.3.2.1.6.4]
b. 27 Sep 1899
11
Laura Annie Chapin
[1.1.1.1.4.4.1.3.2.1.7]
b. 4 Apr 1869
Harry Davis Fluhart
b. 2 Feb 1861
12
Paul Gilbert Fluhart
[1.1.1.1.4.4.1.3.2.1.7.1]
b. 6 Oct 1890
12
Fred Chapin Fluhart
[1.1.1.1.4.4.1.3.2.1.7.2]
b. 23 Nov 1891 d. Bef 1979
12
Laura Fluhart
[1.1.1.1.4.4.1.3.2.1.7.3]
b. 13 Apr 1894 d. Bef 1970
12
Lucille Fluhart
[1.1.1.1.4.4.1.3.2.1.7.4]
b. 6 Aug 1896 d. Bef 1954
12
Richmond Fluhart
[1.1.1.1.4.4.1.3.2.1.7.5]
b. 18 Nov 1899 d. Bef 1941
11
William Robert Chapin
[1.1.1.1.4.4.1.3.2.1.8]
b. 24 Mar 1875 d. 5 Dec 1905
+
June Pierce Mott
b. Abt 1877
10
Jane Chapin
[1.1.1.1.4.4.1.3.2.2]
b. 1833
10
Patrick Henry Chapin
[1.1.1.1.4.4.1.3.2.3]
b. 22 Aug 1834 d. 1886
Mary Louise Wadleigh
b. 1837
11
Frank Beverly Chapin
[1.1.1.1.4.4.1.3.2.3.1]
b. 28 Nov 1862
Lucy Agnes Samuel
b. 12 Mar 1863
12
Margaret Lucy Chapin
[1.1.1.1.4.4.1.3.2.3.1.1]
b. 1 Sep 1893
11
Maud Chapin
[1.1.1.1.4.4.1.3.2.3.2]
b. 11 Jun 1864 d. 11 May 1866
11
Luke Wadleigh Chapin
[1.1.1.1.4.4.1.3.2.3.3]
b. 10 Mar 1867 d. 14 Oct 1921
Viola Lucy Harding
b. 27 Apr 1868
12
Willis Lee Chapin
[1.1.1.1.4.4.1.3.2.3.3.1]
b. 29 May 1892 [
=>
]
12
Mary Chapin
[1.1.1.1.4.4.1.3.2.3.3.2]
b. 20 Dec 1896
11
Willis Chapin
[1.1.1.1.4.4.1.3.2.3.4]
b. 23 Feb 1870 d. 29 Jun 1874
11
Nealy Chapin
[1.1.1.1.4.4.1.3.2.3.5]
b. 8 Sep 1875 d. 12 Jul 1956
10
Mary Ann "Rene" Chapin
[1.1.1.1.4.4.1.3.2.4]
b. 4 Nov 1836 d. Aft 1889
+
John Adams Pence
b. 12 Aug 1830 d. 8 Mar 1912
10
John Ebenezer Chapin
[1.1.1.1.4.4.1.3.2.5]
b. 10 Mar 1840
Sarah Saviela Russel
b. 15 Dec 1845
11
Mary Katherine Capin
[1.1.1.1.4.4.1.3.2.5.1]
b. 5 Mar 1873
11
Olive Russel Chapin
[1.1.1.1.4.4.1.3.2.5.2]
b. 31 May 1876
11
Ernest Chapin
[1.1.1.1.4.4.1.3.2.5.3]
b. 21 Aug 1882
10
Flora Ann Chapin
[1.1.1.1.4.4.1.3.2.6]
b. Abt 1842
10
James Chapin
[1.1.1.1.4.4.1.3.2.7]
b. Abt 1844
11
Nealy Chapin
[1.1.1.1.4.4.1.3.2.7.1]
b. Abt 1870
10
Andrew Gregg Chapin
[1.1.1.1.4.4.1.3.2.8]
b. 13 Sep 1845 d. 10 Apr 1846
9
John Scott Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.3]
b. 22 Feb 1808 d. 14 Jan 1890
+
Sarah Chapin
b. Abt 1810 d. 8 Aug 1865
9
Orpha Edson Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.4]
b. 24 May 1810 d. 9 Jun 1875
+
Willis Edson
b. Abt 1810
Ira Woods
b. 2 Jan 1792 d. 4 Aug 1851
10
Clarissa E Woods
[1.1.1.1.4.4.1.3.4.1]
b. May 1840 d. 10 Sep 1908
Alexander McGowan
b. 20 Jul 1835 d. 23 Jul 1901
11
Ida Lecicena McGowan
[1.1.1.1.4.4.1.3.4.1.1]
b. 16 Sep 1856 d. 14 Mar 1934
William Fletcher Soper
b. 3 Jun 1851 d. 27 Oct 1930
12
Orville Soper
[1.1.1.1.4.4.1.3.4.1.1.1]
b. 11 Apr 1878 d. 6 Jan 1956 [
=>
]
12
Edith Soper
[1.1.1.1.4.4.1.3.4.1.1.2]
b. 13 Nov 1879 d. 3 Mar 1893
12
James Lee Soper
[1.1.1.1.4.4.1.3.4.1.1.3]
b. 18 Jan 1895 d. 2 Jan 1947
11
Orpha C McGowan
[1.1.1.1.4.4.1.3.4.1.2]
b. Abt 1858 d. Bef 1892
Francis Percival Adams
b. Abt 1849 d. 1929
12
Nellie I Adams
[1.1.1.1.4.4.1.3.4.1.2.1]
b. Feb 1880
12
James Adams
[1.1.1.1.4.4.1.3.4.1.2.2]
b. Oct 1884
11
Katherine A McGowan
[1.1.1.1.4.4.1.3.4.1.3]
b. Apr 1862 d. 1954
William Stoalabarger
b. Jan 1859 d. 11 Jan 1954
12
Pearl A Stoalabarger
[1.1.1.1.4.4.1.3.4.1.3.1]
b. May 1879
12
Lulu Stoalabarger
[1.1.1.1.4.4.1.3.4.1.3.2]
b. Dec 1883
12
Percy W Stoalabarger
[1.1.1.1.4.4.1.3.4.1.3.3]
b. Jun 1886
12
Ersel Reuben Stoalabarger
[1.1.1.1.4.4.1.3.4.1.3.4]
b. 31 Dec 1894
12
Glenn E Stoalabarger
[1.1.1.1.4.4.1.3.4.1.3.5]
b. 24 Feb 1901 d. 13 Aug 1970
11
James Willis McGowan
[1.1.1.1.4.4.1.3.4.1.4]
b. Oct 1870
10
Nealy Chapin Woods
[1.1.1.1.4.4.1.3.4.2]
b. 12 Jun 1842 d. 23 May 1918
Cecelia Loretta Stafford
b. 26 Aug 1842 d. 11 Aug 1914
11
Mildred F "May" Woods
[1.1.1.1.4.4.1.3.4.2.1]
b. 16 Oct 1868 d. Aft 1918
11
Willis E Woods
[1.1.1.1.4.4.1.3.4.2.2]
b. 7 Mar 1870 d. 3 Jun 1870
11
Fred Emmett Woods
[1.1.1.1.4.4.1.3.4.2.3]
b. 21 Nov 1872 d. 29 Sep 1899
Ethel Chaffee
b. Abt 1874 d. 25 Mar 1974
12
Nealy Chaffee Woods
[1.1.1.1.4.4.1.3.4.2.3.1]
b. 27 Feb 1897 d. May 1971
12
Walter Wayne Woods
[1.1.1.1.4.4.1.3.4.2.3.2]
b. 16 Jul 1898 d. 20 Sep 1972
12
Fred Emmett Woods, Jr
[1.1.1.1.4.4.1.3.4.2.3.3]
b. 24 Feb 1900 d. 20 Mar 1980 [
=>
]
11
Grace Agnes Woods
[1.1.1.1.4.4.1.3.4.2.4]
b. 1 Nov 1875 d. 18 Dec 1966
Charles Fidellio Blackstock
b. 30 Dec 1875 d. 19 Sep 1966
12
Mabel Abigail Blackstock
[1.1.1.1.4.4.1.3.4.2.4.1]
b. 12 Jul 1897 d. 13 Jun 1989 [
=>
]
12
Mildred Blackstock
[1.1.1.1.4.4.1.3.4.2.4.2]
b. 25 Oct 1899 d. 15 Apr 1979 [
=>
]
12
Jeanette Blackstock
[1.1.1.1.4.4.1.3.4.2.4.3]
b. 2 Apr 1903 d. 29 Jun 1991
12
Bernice Blackstock
[1.1.1.1.4.4.1.3.4.2.4.4]
b. 9 Dec 1905 d. 29 Dec 1984
11
Nealey Clarance Woods
[1.1.1.1.4.4.1.3.4.2.5]
b. 5 Jun 1880 d. 9 Mar 1881
10
Phebe Woods
[1.1.1.1.4.4.1.3.4.3]
b. Abt 1844 d. Bef 1908
10
Emily Woods
[1.1.1.1.4.4.1.3.4.4]
b. Abt 1846 d. Bef 1908
10
Orpha Woods
[1.1.1.1.4.4.1.3.4.5]
b. 21 Apr 1850 d. 17 Sep 1938
Eugene Preston Foster
b. 4 Apr 1848 d. Abt 1934
11
Orpha W Foster
[1.1.1.1.4.4.1.3.4.5.1]
b. 9 Jun 1875 d. 14 Mar 1973
11
Lucy Adeline Foster
[1.1.1.1.4.4.1.3.4.5.2]
b. 19 Jan 1877 d. 14 Sep 1877
11
Grace Foster
[1.1.1.1.4.4.1.3.4.5.3]
b. 30 Jul 1878 d. 19 Sep 1972
Stephen Hugh Percy
b. 16 Oct 1884 d. 30 Jun 1967
12
Eugene Foster Percy
[1.1.1.1.4.4.1.3.4.5.3.1]
b. 17 Nov 1906 d. 13 Aug 1978 [
=>
]
12
Margaret Percy
[1.1.1.1.4.4.1.3.4.5.3.2]
b. Abt 1908 d. Abt 1934
11
Edith Annie Foster
[1.1.1.1.4.4.1.3.4.5.4]
b. 11 Jul 1881
+
Fred Mercer
b. Abt 1895 d. Abt 1940
11
Ida Foster
[1.1.1.1.4.4.1.3.4.5.5]
b. 31 May 1885
11
Alex Cheney Foster
[1.1.1.1.4.4.1.3.4.5.6]
b. 25 Jul 1887 d. 25 Jan 1888
11
Willis Edson Foster
[1.1.1.1.4.4.1.3.4.5.7]
b. 3 Nov 1888 d. 29 Mar 1889
11
Frank Preston Foster
[1.1.1.1.4.4.1.3.4.5.8]
b. 3 Nov 1888 d. 31 Mar 1889
11
Mildred Foster
[1.1.1.1.4.4.1.3.4.5.9]
b. 9 Jul 1892
Phillip Ranger
b. Abt 1890
12
Phillip Ranger
[1.1.1.1.4.4.1.3.4.5.9.1]
b. 9 Feb 1920 d. Apr 1979
12
Living
[1.1.1.1.4.4.1.3.4.5.9.2]
11
Eugene Cheney Foster
[1.1.1.1.4.4.1.3.4.5.10]
b. 28 Nov 1895 d. 15 Apr 1903
Abigail Durfee
b. 1780 d. Aug 1820
9
Stephen Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.5]
b. 11 Oct 1816 d. 1833
9
Simeon Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6]
b. 14 Aug 1818 d. 23 Jun 1898
Martha McCrary Rea
b. 30 Mar 1822 d. 5 Jan 1907
10
Edmond M Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.1]
b. 1 Jan 1840 d. 20 Oct 1866
10
Louisa Jane Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.2]
b. 24 Jul 1841 d. 3 Dec 1863
John Digby
b. 1836
11
Flora Digby
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.2.1]
b. 24 Jul 1841
Wright James Conner
b. 30 Jun 1854 d. 31 Jul 1927
12
Gamet Connor
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.2.1.1]
b. 1880
12
Mary Elizabeth Connor
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.2.1.2]
b. 1880
12
Fred Connor
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.2.1.3]
b. 1885
12
Martha Arvilla Conner
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.2.1.4]
b. 1 Oct 1889 d. 10 Jun 1955
12
Flossie Connor
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.2.1.5]
b. 1890
12
Graes Connor
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.2.1.6]
b. 1890
12
Raymond Connor
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.2.1.7]
b. 1894
12
Hazel Connor
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.2.1.8]
b. 1895
10
Elizabeth M Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.3]
b. 8 Jan 1844 d. Sep 1844
10
Simeon Taylor Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4]
b. 22 Dec 1846 d. 18 Sep 1935
Nancy Marilla Watson
b. 6 Dec 1850 d. 30 Oct 1934
11
Nealy Ellis Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.1]
b. 6 Nov 1868 d. 15 Nov 1954
Cora Maude Campbell
b. 16 Oct 1871 d. 18 Nov 1949
12
Donald Earl Clinton Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.1.1]
b. 1899 d. May 1972
12
Melville C Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.1.2]
b. 1902 d. Jul 1974
12
Everett E Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.1.3]
b. 1906 d. 1969
11
John Scott Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.2]
b. 28 Aug 1870 d. 19 Jul 1941
Bertha Constance Pennington
b. 1889
12
Dorothy H Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.2.1]
b. 1912 d. 1984
12
Eugene Victor Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.2.2]
b. 1914 d. 17 May 1997
12
Kenneth Taylor Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.2.3]
b. 1916 d. 9 Mar 1916
+
Ida Fattig
b. Abt 1874
11
Edward Taylor Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.3]
b. 12 Jul 1872 d. 23 Oct 1934
Leonora Robbins
b. 30 Jun 1875 d. 11 Feb 1948
12
Ruby Marilla Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.3.1]
b. 24 Jan 1896 d. 4 Apr 1896
12
Hattie Elnora Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.3.2]
b. 17 Sep 1898 d. 21 Mar 1981 [
=>
]
12
Helen A Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.3.3]
b. 17 Sep 1898
12
Chester Eugene Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.3.4]
b. 15 Jun 1900 d. 1902
12
Louella Irene Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.3.5]
b. 10 Oct 1901 d. 28 Jul 1902
12
Phebe Winnie Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.3.6]
b. 26 Oct 1903 d. 25 Mar 1904
12
Vernon Oscar Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.3.7]
b. 8 Aug 1906 d. 24 Nov 1979 [
=>
]
12
Fred D Warren Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.3.8]
b. 4 Dec 1910 d. Apr 1987
12
Frank Montgomery Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.3.9]
b. 28 Dec 1913 d. 28 Jul 1997
12
Bernice May Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.3.10]
b. 17 Aug 1916 d. Dec 1986
12
Florence Louise Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.3.11]
b. 23 Apr 1918 d. 19 Nov 1990 [
=>
]
12
June Effie Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.3.12]
b. 21 Jun 1920 d. 10 Jul 1991 [
=>
]
11
Willis Ebenezer Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.4]
b. 11 Apr 1874 d. 5 May 1936
Leora Agnes Pennington
b. 8 Sep 1878 d. 29 Oct 1967
12
Francis Ward Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.4.1]
b. 25 Sep 1895 d. 11 Dec 1937
12
Bessie Clara Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.4.2]
b. 19 Dec 1898 d. 1 May 1989 [
=>
]
12
Clarance Albert Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.4.3]
b. 20 Mar 1906 d. 13 Sep 1906
12
Byron Murill Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.4.4]
b. 16 Feb 1910 d. 7 Mar 1986
12
Sylvia Irilla Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.4.5]
b. 20 Jun 1913 d. 14 Apr 2001
11
Clara Elnora Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.5]
b. 14 Mar 1876 d. 13 Jun 1951
Olen E. Bross
b. 5 Jul 1875 d. 1968
12
Leta L Bross
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.5.1]
b. 1902
12
Robert J Bross
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.5.2]
b. 25 Dec 1904 d. Sep 1973
11
Charley Walter Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.6]
b. 15 Dec 1877 d. 7 Apr 1962
Lida Blanch Holmes
b. 31 May 1881 d. 15 Jul 1968
12
Fern Violet Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.6.1]
b. 10 Oct 1900 d. 23 Aug 1902
12
Earl Fremont Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.6.2]
b. 28 Jun 1903 d. 26 Apr 1959
12
Ethel Irene Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.6.3]
b. 9 Feb 1905 d. 14 May 1911
12
Lester Vernon Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.6.4]
b. 1 Nov 1906 d. 2 Feb 1984 [
=>
]
12
Forrest Francis Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.6.5]
b. 2 Sep 1909 d. 10 Feb 1996
12
Charley Harold Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.6.6]
b. 23 Aug 1914 d. 19 Jul 2003
12
Clinton Sylvester Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.6.7]
b. 21 Sep 1916 d. 15 Jan 2006
11
Olive Selona Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.7]
b. 12 Jan 1881 d. 8 May 1924
Vincent Eugene Crow
b. 28 Jan 1879 d. 10 Jan 1959
12
Charles F Crow
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.7.1]
b. Feb 1898 d. Jul 1974 [
=>
]
12
Cora F Crow
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.7.2]
b. Apr 1900
12
Nellie M Crow
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.7.3]
b. Apr 1900
12
Percy V Crow
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.7.4]
b. 1903
11
George Wesley Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.8]
b. 18 Mar 1883 d. 15 Mar 1957
+
Eff Pennington
b. Abt 1887
11
Clarence Albert Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.9]
b. 14 Jun 1887 d. 15 May 1888
11
Millia Grace Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.10]
b. 13 May 1889 d. 18 Dec 1981
Lucine Everett Shinn
b. 17 Sep 1882 d. 18 Feb 1981
12
Gladys I Shinn
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.10.1]
b. 1910
12
Clifford Everett Shinn
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.10.2]
b. 7 Oct 1910 d. 13 Jul 1929
12
Harold Eugene Shinn
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.10.3]
b. 4 Aug 1912 d. 4 Aug 1912
12
Living
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.10.4]
12
Jay W Shinn
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.10.5]
b. 30 Jan 1919 d. 6 Jun 2002
11
Henry Ward "Beecher" Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.11]
b. 4 Feb 1892 d. 8 Feb 1945
Nancy Lovisa Sumpter
b. 3 Sep 1894 d. 20 Sep 1975
12
Gladys Lovisa Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.11.1]
b. 31 Oct 1914 d. 30 Dec 2001
12
Henry Ward Beecher "Bee" Daggett, Jr
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.11.2]
b. 1919 bur. 1993
12
Harold Billie Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.11.3]
b. 16 Apr 1928 d. 23 Apr 1928
11
Lewis Rea Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.4.12]
b. 16 Sep 1895 d. 3 Jan 1976
+
Lydia Nevada Rogers
b. 6 Feb 1898 d. 1 May 1976
10
John Scott Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.5]
b. Abt 1848 d. Mar 1850
10
Silas Clark Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.6]
b. 13 May 1852 d. 1930
Lucy D Shields
b. 4 Aug 1856 d. 1 Jan 1925
11
Etta May Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.6.1]
b. 20 Jan 1874 d. 23 Jul 1905
Frank Bush Headrick
b. 9 Mar 1873 d. 26 Mar 1952
12
Iva Ruth Headrick
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.6.1.1]
b. 16 Jan 1895 d. 17 Feb 1900
12
Birdie Maud Headrick
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.6.1.2]
b. 2 Nov 1896 d. 5 Feb 1967 [
=>
]
12
Ella Fay Headrick
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.6.1.3]
b. 3 Mar 1899 d. 17 Jun 1984 [
=>
]
12
Minnie May Headrick
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.6.1.4]
b. 3 Mar 1899 d. Apr 1981
12
Ray Headrick
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.6.1.5]
b. 17 Jun 1905 d. 18 Jun 1905
11
Florance Elba Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.6.2]
b. 6 Dec 1876 d. 22 Nov 1957
William Gourd
b. 10 Mar 1862 d. 17 Jan 1928
12
Clarence Byron Gourd
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.6.2.1]
b. 18 Nov 1894 d. 10 Apr 1968
12
Florence Mable Gourd
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.6.2.2]
b. Feb 1896
12
Ida Blanche Gourd
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.6.2.3]
b. 14 Nov 1896 [
=>
]
12
Theron Clarence Gourd
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.6.2.4]
b. 1903 d. 1943
12
Ethel M Gourd
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.6.2.5]
b. 24 Mar 1906 d. 10 Aug 1993
11
Benjamin Henry Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.6.3]
b. 14 Mar 1879 d. 10 May 1960
Clara May Thorson
b. 30 Oct 1882 d. 10 May 1960
12
Harry Byron Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.6.3.1]
b. 2 Feb 1902 d. 10 Dec 1927
12
Lillian P Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.6.3.2]
b. 21 May 1903 d. 16 Jun 1967
12
Cleo Margaret Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.6.3.3]
b. 12 Jun 1911
11
Ruth Elizabeth Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.6.4]
b. 5 Jan 1881
11
Viva Pearl Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.6.5]
b. Dec 1890
10
Martha Salena Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.7]
b. 26 Aug 1859 d. 5 Jan 1902
+
Lewis Franklin Davis
b. 2 Nov 1856
10
Frank Smith Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.8]
b. 18 May 1864 d. 1902
Elizabeth Bell Burget
b. 7 May 1869 d. 1939
11
Martha Edna Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.3.6.8.1]
b. 2 Feb 1889
+
Leroy Edward Hill
8
Simeon Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.4]
b. 11 Jun 1779 d. 25 Jan 1823
+
Sallie Putnam
b. 1782
8
Polly Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.5]
b. 14 Feb 1781 d. 1 Nov 1813
Amasa Bancroft
b. 19 Mar 1778 d. 6 Feb 1812
9
Lucy Bancroft
[1.1.1.1.4.4.1.5.1]
b. 30 Mar 1802
Banabus Hammett Snow
d. 31 May 1873
10
Polly Bancroft Snow
[1.1.1.1.4.4.1.5.1.1]
b. 28 Nov 1823 d. 7 Sep 1860
Mark Richardson Putnam
b. 6 Nov 1817 d. 13 May 1873
11
Clarence Frances Putnam
[1.1.1.1.4.4.1.5.1.1.1]
b. 7 Mar 1848
10
Kate Daggett Snow
[1.1.1.1.4.4.1.5.1.2]
b. 11 Oct 1826
10
Emaline Snow
[1.1.1.1.4.4.1.5.1.3]
b. 20 Sep 1829
10
Avis Snow
[1.1.1.1.4.4.1.5.1.4]
b. 17 Mar 1832
9
Nancy Bancroft
[1.1.1.1.4.4.1.5.2]
b. 1804
9
Cornelius Watrous Bancroft
[1.1.1.1.4.4.1.5.3]
b. 1808 d. 22 Jan 1856
+
Lucy B Howard
b. 1808
9
Carlos Bancroft
[1.1.1.1.4.4.1.5.4]
b. 20 Mar 1809 d. 24 Oct 1876
Mary E Johnston
b. 4 Jul 1813 d. 15 Sep 1856
10
Jane Sophia Bancroft
[1.1.1.1.4.4.1.5.4.1]
b. 1 Oct 1841
10
Arthur Daggett Bancroft
[1.1.1.1.4.4.1.5.4.2]
b. 29 Aug 1843
Juliette E Camp
b. 3 Aug 1844
11
Carlos Campbell Bancroft
[1.1.1.1.4.4.1.5.4.2.1]
b. 25 Jun 1871 d. 1910
Harriet Emily Huse
b. 5 Jun 1873
12
Rachel Bancroft
[1.1.1.1.4.4.1.5.4.2.1.1]
b. 1 Sep 1901
12
Margaret Emily Bancroft
[1.1.1.1.4.4.1.5.4.2.1.2]
b. 16 Jul 1903
11
Jane Bancroft
[1.1.1.1.4.4.1.5.4.2.2]
b. 27 Feb 1879
10
Carlos Amasa Bancroft
[1.1.1.1.4.4.1.5.4.3]
b. 15 Sep 1845 d. 1846
10
Charles Eastman Bancroft
[1.1.1.1.4.4.1.5.4.4]
b. 23 Apr 1848 d. 6 Aug 1848
10
Carlos Johnston Bancroft
[1.1.1.1.4.4.1.5.4.5]
b. 18 May 1852 d. 6 Aug 1863
10
Frederick Wallace Bancroft
[1.1.1.1.4.4.1.5.4.6]
b. 15 Sep 1855
9
Amasa Bancroft
[1.1.1.1.4.4.1.5.5]
b. 4 Mar 1811
8
Cate Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.6]
b. 4 Apr 1786
8
Lucy Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.7]
b. 27 Sep 1789
8
Mehitable Daggett
[1.1.1.1.4.4.1.8]
b. 1793 d. 14 Aug 1844
7
Mehetabel Daggett
[1.1.1.1.4.4.2]
b. 10 Oct 1752 d. 20 Apr 1834
Jonathon Rich
b. 20 Jul 1747 d. 28 Aug 1828
8
Reuben Rich
[1.1.1.1.4.4.2.1]
b. 26 Apr 1775
8
Simeon Rich
[1.1.1.1.4.4.2.2]
b. 6 Mar 1780 d. 11 Sep 1855
Patty Ward
b. 19 Dec 1779
9
Gibert Rich
[1.1.1.1.4.4.2.2.1]
b. 29 Nov 1806
Huldah Gould Lamson
b. 26 Oct 1815 d. 20 Jan 1845
10
Arthur Rich
[1.1.1.1.4.4.2.2.1.1]
b. 27 Dec 1841
10
Alonzo Gilbert Rich
[1.1.1.1.4.4.2.2.1.2]
b. 20 Oct 1843
9
Loisa Rich
[1.1.1.1.4.4.2.2.2]
b. Bef 1809
+
Lewis Blood
b. Abt 1809
9
Diantha Rich
[1.1.1.1.4.4.2.2.3]
b. 1 Jun 1817
Robert Craig
b. 30 Oct 1805
10
Esther Craig
[1.1.1.1.4.4.2.2.3.1]
b. Abt 1844
10
Martha Craig
[1.1.1.1.4.4.2.2.3.2]
b. Abt 1847
10
Emily Lorinda Craig
[1.1.1.1.4.4.2.2.3.3]
b. 28 Apr 1851
10
Martha L Craig
[1.1.1.1.4.4.2.2.3.4]
b. 9 Jun 1860
Willis Asa Taft
b. 16 Jun 1856
11
Robert Beals Taft
[1.1.1.1.4.4.2.2.3.4.1]
b. 7 Jan 1882
+
Florence Marion Lamson
b. 26 Dec 1885
11
Arthur Corbin Taft
[1.1.1.1.4.4.2.2.3.4.2]
b. 12 May 1890
11
Richard Craig Taft
[1.1.1.1.4.4.2.2.3.4.3]
b. 3 Jan 1893
9
Erastus Rich
[1.1.1.1.4.4.2.2.4]
b. Sep 1809
9
Lucetta Rich
[1.1.1.1.4.4.2.2.5]
b. 8 Mar 1820 d. Aft 1870
+
Cyrus Lamb
b. 2 Nov 1818 d. 12 Apr 1882
9
Louisa Rich
[1.1.1.1.4.4.2.2.6]
b. 6 Apr 1812
9
Lorinda Rich
[1.1.1.1.4.4.2.2.7]
b. 3 Nov 1814 d. Sep 1844
8
Arthur Rich
[1.1.1.1.4.4.2.3]
b. 13 Oct 1777
+
Ruby Titus
b. Abt 1781
8
Cynthia Rich
[1.1.1.1.4.4.2.4]
b. Abt 1779
+
Dexter Carbin
b. Abt 1775
8
Jonathan Rich, Jr
[1.1.1.1.4.4.2.5]
b. 19 Nov 1782
8
Paul Rich
[1.1.1.1.4.4.2.6]
b. 16 Aug 1785
8
Barnabas Rich
[1.1.1.1.4.4.2.7]
b. 13 Oct 1787
+
Lucy Nichols
b. 17 May 1796 d. 20 Feb 1868
7
Simeon Daggett
[1.1.1.1.4.4.3]
b. 7 Mar 1757 d. 9 May 1819
Anna Dean
b. 1759 d. 9 May 1819
8
Nancy Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.1]
b. Abt 1779
+
Amos Putney
b. 10 Feb 1789
8
Simeon Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.2]
b. 1780 d. 17 Jun 1854
Susan Towle
b. 1795 d. 15 Jul 1874
9
Elias Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.2.1]
b. 1816
+
Mary A
b. 1825
9
Lydia A Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.2.2]
b. 1819
9
Susan T Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.2.3]
b. 1823 d. 22 Oct 1907
9
Mary Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.2.4]
b. 1825 d. 26 May 1863
+
Benson Banton
b. Abt 1823
9
Simeon Orval Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.2.5]
b. 1827
Mary Putnam
b. 1828
10
George Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.2.5.1]
b. 30 Aug 1847
10
Homer Putnam Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.2.5.2]
b. 1850 d. 30 May 1924
Abbie C Cromwell
b. 2 Apr 1869 d. 27 Feb 1949
11
Charles Orville Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.2.5.2.1]
b. 1 Aug 1887 d. May 1960
Grace Ellen Petteys
b. 20 Feb 1890 d. 16 May 1964
12
Naomi Dell Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.2.5.2.1.1]
b. 22 Nov 1912 d. 10 May 1983
12
Geraldine Louise Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.2.5.2.1.2]
b. 23 Aug 1915 d. 21 Nov 1997
12
Charles Jay Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.2.5.2.1.3]
b. 2 Jul 1917 d. 1986
12
Dorothy Jean Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.2.5.2.1.4]
b. 16 Nov 1919 d. Dec 1970
12
Thelma Jeanette Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.2.5.2.1.5]
b. 29 Apr 1922 d. 19 Mar 1992
12
Jack Dudley Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.2.5.2.1.6]
b. 23 Jun 1926 d. 18 Jan 2013
12
Glen Cromwell Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.2.5.2.1.7]
b. 10 Apr 1928 d. 27 May 1995
12
Dolores Ruth Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.2.5.2.1.8]
b. 3 Aug 1929 d. 27 Jan 1985
12
William Ray Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.2.5.2.1.9]
b. 22 Jul 1933 d. 26 May 1957
12
Diane Lee Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.2.5.2.1.10]
b. 18 Jun 1937 d. 12 Sep 2012
11
Jennie I Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.2.5.2.2]
b. 23 Sep 1888 d. Mar 1910
+
Fred Hartman
b. Abt 1886
11
Harry C Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.2.5.2.3]
b. 20 Apr 1891 d. 28 Apr 1962
+
Isla E Overby
b. Abt 1893
11
Lillian G Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.2.5.2.4]
b. 1899
+
Lee L Steinhaus
b. Abt 1897
11
Gilman C Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.2.5.2.5]
b. 1901
+
Ruth Lane
b. Abt 1903
11
Edythe M Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.2.5.2.6]
b. 10 May 1906 d. 13 Feb 1947
+
Karl Hirst Branch
b. 9 Sep 1901 d. 17 Jan 1966
10
Mary J Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.2.5.3]
b. 1852 d. 1912
+
John Green
b. Abt 1850
10
Morris Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.2.5.4]
b. 1854
Rose E Pomeroy
b. 1859
11
Claude Henry Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.2.5.4.1]
b. 24 Jul 1878 d. Sep 1939
Floy R Schallock
b. 6 Nov 1881 d. Mar 1953
12
Claude H Daggett, Jr
[1.1.1.1.4.4.3.2.5.4.1.1]
b. Abt 1903
11
Son Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.2.5.4.2]
b. 1880
11
Son Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.2.5.4.3]
b. 2 Sep 1883
10
Gilman Towle Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.2.5.5]
b. 1859 d. 13 Nov 1930
+
Minnie C Todd
b. Abt 1861
10
Nina Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.2.5.6]
b. Abt 1860
10
Susan Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.2.5.7]
b. 8 Apr 1862
+
Elizabeth King
b. Abt 1825
8
Sally Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.3]
b. 1782
8
Son Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.4]
b. Abt 1784
8
Nathaniel Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5]
b. 12 Jul 1785 d. Abt 1827
Maltilda Farwell
b. 17 Jun 1794 d. 4 Oct 1883
9
Catherine Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.1]
b. 20 Jun 1811 d. 19 Nov 1861
+
Henry John Richardson
c. 18 Jan 1809
9
Lorenzo Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2]
b. 14 Feb 1813 d. 24 Nov 1889
Henrieta Chipman
b. 5 Oct 1817 d. 12 May 1847
10
John F Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.1]
b. 25 Feb 1837 d. 15 Feb 1897
Hanna Dora Mansur
b. 13 Nov 1846 d. 29 Jan 1911
11
Henrietta Deborah Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.1.1]
b. 28 Aug 1865 d. 18 Jun 1943
John H Willets
b. 20 Apr 1860 d. 17 Feb 1913
12
William F Willitts
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.1.1.1]
b. 16 Jul 1883 d. 29 May 1955
12
Chalmar Willitts
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.1.1.2]
b. 19 Aug 1887 d. 16 Apr 1941
12
Ray Willitts
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.1.1.3]
b. 13 Jan 1890 d. 21 Sep 1950
11
Alford Lorenzo Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.1.2]
b. 12 Mar 1867 d. 14 Apr 1949
Mary L McDermond
b. 29 Mar 1867 d. 2 Dec 1930
12
Florence Rae Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.1.2.1]
b. 7 Jul 1891 d. Oct 1985 [
=>
]
12
Dora Natalie Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.1.2.2]
b. 8 Jan 1897
12
Elfleda Dagget
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.1.2.3]
b. 24 Dec 1899
12
Loraine Maxine Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.1.2.4]
b. 19 Aug 1912 d. 5 Feb 2005
11
John William Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.1.3]
b. 18 Jan 1869 d. 1 Jun 1932
Lottie E Tice
b. 16 Apr 1871 d. 3 Feb 1920
12
Margaret May Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.1.3.1]
b. 17 Sep 1891 d. 12 Aug 1913
12
Carl Farwell Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.1.3.2]
b. 1895 d. 1895
12
John Arthur Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.1.3.3]
b. 13 Jun 1897 d. 4 Feb 1920 [
=>
]
12
Violet Amelie Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.1.3.4]
b. 1900 d. 1900
12
Floyd LeRoy Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.1.3.5]
b. 1905 d. 1905
12
Ruth Irene Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.1.3.6]
b. 1912 d. 1912
12
Son Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.1.3.7]
b. 1913 d. 1913
11
Charles Henry Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.1.4]
b. 9 Oct 1871 d. 9 Jun 1959
+
Flora B Hunker
b. 26 Jul 1874 d. 5 Aug 1960
11
Helen Adelia Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.1.5]
b. 17 Jun 1876 d. 26 Jul 1941
Rufus Wortham Blain
b. 4 Mar 1871 d. 17 Feb 1939
12
Howard Wortham Blain
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.1.5.1]
b. 29 May 1896 d. 17 Apr 1963
12
Helen Irene Blain
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.1.5.2]
b. 5 Aug 1904 d. 28 Jan 1955
11
James Arthur Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.1.6]
b. 31 Dec 1882 d. 16 Mar 1964
Pearl Purdy
b. 13 Nov 1883 d. 3 Jan 1970
12
John Kenneth Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.1.6.1]
b. 21 Mar 1910 d. 21 Mar 1910
12
Ruth Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.1.6.2]
b. 17 Mar 1912 d. 29 Sep 1912
12
Vera Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.1.6.3]
b. 18 Apr 1915 d. 4 Jan 1969
10
Hannah Matilda Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.2]
b. 15 Dec 1838 d. 3 Jan 1905
John Henry Bennett
b. 27 Apr 1839 d. 7 Jul 1897
11
Luther Bennett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.2.1]
b. 12 Nov 1858 d. 17 May 1936
Sophia Ann Karls
b. 30 Oct 1865 d. 20 Sep 1944
12
Olivene Edith Bennett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.2.1.1]
b. 27 Oct 1882 d. 21 Apr 1953 [
=>
]
12
Charles Henry Bennett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.2.1.2]
b. 15 Oct 1884 d. 18 Sep 1935 [
=>
]
12
John Herbert Bennett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.2.1.3]
b. 6 Aug 1886 d. 3 Feb 1961 [
=>
]
12
William Harrison Bennett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.2.1.4]
b. 26 Mar 1888 d. 16 Jun 1946
12
Grace Gertrude Bennett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.2.1.5]
b. 24 Mar 1890 d. 3 Jul 1926
12
Bertha Lillian Bennett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.2.1.6]
b. 3 Nov 1892 d. 14 Jun 1958 [
=>
]
12
Zetta March Bennett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.2.1.7]
b. 27 Mar 1895 d. 29 Jul 1976
12
Myrtle Aleda Bennett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.2.1.8]
b. 14 Jun 1897 d. 19 Oct 1973
12
Clifford Bennett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.2.1.9]
b. 23 Apr 1899 d. 23 Apr 1899
12
Ruby Leona Bennett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.2.1.10]
b. 5 Dec 1901 d. 6 Dec 1966 [
=>
]
11
John Henry Bennett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.2.2]
c. 29 May 1859 d. 19 Aug 1861
11
John Andrew Bennett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.2.3]
b. 19 Aug 1860 d. 6 May 1861
11
Phebe Louella Bennett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.2.4]
b. 11 Feb 1865 d. 16 Nov 1925
Milan Jennings
b. 13 Mar 1858 d. 30 Sep 1919
12
Glennie Beatrice Jennings
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.2.4.1]
b. 29 Mar 1890 d. 19 Mar 1919
12
Velma Maple Jennings
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.2.4.2]
b. 12 Jun 1897 d. 12 Apr 1978 [
=>
]
12
Letha Ermin Jennings
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.2.4.3]
b. 23 Jun 1900
12
Leland Loren Jennings
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.2.4.4]
b. 23 Jun 1900 d. 3 Jun 1963
11
Lorenzo Jesse Bennett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.2.5]
b. 31 Mar 1873 d. 10 Apr 1938
Jeanette Mae Kinney
b. Abt 1877 d. 25 Feb 1937
12
Gladys Faye Bennett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.2.5.1]
b. 7 Aug 1896 d. Feb 1973
12
Luther Lloyd Bennett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.2.5.2]
b. 16 Jan 1899 d. 19 Jun 1954
12
Beatrice Mae Bennett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.2.5.3]
b. 30 Nov 1901 d. 25 Jul 1973 [
=>
]
Ethyl Maud Hoisington
b. 11 Dec 1881 d. 25 May 1925
12
Eva Marie Bennett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.2.5.4]
b. 2 May 1904 d. 23 Sep 1967
12
Howard Earl Bennett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.2.5.5]
b. 29 Aug 1906 d. 3 Jul 1989
12
Estella Leona Bennett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.2.5.6]
b. 18 Apr 1909 d. 3 Sep 1998
12
Leslie Donald Bennett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.2.5.7]
b. 7 Jun 1912 d. 21 Sep 1992
12
Erma Lorraine Bennett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.2.5.8]
b. 8 Feb 1914 d. 22 Jan 2004 [
=>
]
12
Hazel Maxine Bennett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.2.5.9]
b. 27 Nov 1917 d. 2003
11
Anna Dell Bennett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.2.6]
b. 23 Feb 1877 d. 25 Sep 1956
Charles Henry Markley
b. 13 Sep 1868 d. 27 Jan 1935
12
Elmer Harry Markley
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.2.6.1]
b. 2 Jul 1896 d. 9 Apr 1933 [
=>
]
12
Viola Mae Markley
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.2.6.2]
b. Abt 1898 d. 31 Oct 1902
12
Alta Velma Markley
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.2.6.3]
b. 18 Oct 1904 d. 10 May 1968
10
Jane Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.3]
b. 5 Aug 1841 d. 3 Sep 1842
10
Melissa Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.4]
b. 31 May 1843 d. Aft 1905
10
Helen May Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.5]
b. 27 Apr 1845
Benjamin R Dickey
b. 6 May 1836 d. 28 Mar 1878
11
Cassius Dickey
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.5.1]
b. Abt 1867 d. 26 Dec 1899
Mary Elizabeth Zena Bro
b. May 1880
12
Blanche Helen Dickey
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.5.1.1]
b. 24 Nov 1899
11
George L Dickey
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.5.2]
b. Abt 1871
+
Mamie Elizabeth Desjardines
11
Alberta Hellen "Birdie" Dickey
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.5.3]
b. Apr 1875 d. 1953
Arthur Francis Cantley
b. 31 Mar 1870 d. 25 Jul 1938
12
U Cantley
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.5.3.1]
b. 19 Feb 1897
12
Emily Mae Cantley
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.5.3.2]
b. Jul 1898 d. 1909
12
Bertah Cantley
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.5.3.3]
b. 12 Oct 1900
12
Vernon Arthur Cantley
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.5.3.4]
b. 10 Feb 1904 d. Dec 1975
11
Cerinda Jane Dickey
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.5.4]
b. 9 Jun 1877 d. 12 Dec 1900
+
Joseph Bro
b. Abt 1878 d. 1926
10
Sylvester Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.6]
b. 30 Apr 1847 d. 30 Apr 1847
Eliza J Jones
b. 4 Mar 1830 d. 1890
10
George Jones Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.7]
b. 22 May 1848 d. 26 Feb 1849
10
Francis J Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.8]
b. 1 Oct 1849 d. Aft 1905
10
Sarah A Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.9]
b. 2 May 1851 d. 1 Dec 1852
10
Nathaniel Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.10]
b. 29 May 1853 d. 3 Sep 1934
Madora Jane Laughlin
b. 12 Mar 1862 d. 7 Mar 1919
11
Loren Alfred Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.10.1]
b. 9 Jan 1880
Ellen McCloud
b. Abt 1886
12
Loren Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.10.1.1]
b. Abt 1902
12
Nathaniel Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.10.1.2]
b. Abt 1904
11
Rose Elva Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.10.2]
b. 11 Dec 1881 d. 1 Sep 1967
+
Edward Loughran
b. Abt 1879
11
Josephine Eva Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.10.3]
b. 27 Jun 1884
+
Thomas Paul "Tim" Andrich
b. Abt 1882
11
Maude E Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.10.4]
b. 18 Feb 1886 d. 28 Oct 1908
Thomas Sylvester McEachran
b. 9 Mar 1873 d. 26 Oct 1938
12
Stanley Sylvester McEachran
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.10.4.1]
b. 15 Nov 1906 d. 9 Oct 1980
11
Harold Edwin Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.10.5]
b. 18 Jul 1892 d. 5 Mar 1967
+
Carroll Dayton
b. 27 Jul 1898
11
Gladys Ruth Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.10.6]
b. 26 Jun 1899 d. 11 Nov 1992
George Stearns Allin
b. 11 Mar 1902 d. 2 Dec 1992
12
George Stearns Allin, Jr
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.10.6.1]
b. Abt 1926 d. 25 Feb 1978
10
Alice G Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.11]
b. 12 Jun 1855
Mary Ann Laken
b. 10 Nov 1813 d. 3 Jun 1905
10
James A Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.12]
b. 27 Jan 1860 d. 19 Oct 1934
Sarah Jane Taylor
b. 8 Nov 1866 d. 20 Jul 1939
11
Myrtle Iva Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.12.1]
b. 18 Nov 1883 d. 24 Apr 1946
Ralph Campbell Hays
b. 12 Feb 1886 d. 5 Jul 1972
12
Raymond Cleatus Hays
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.12.1.1]
b. 5 Jun 1909 d. 9 Feb 1990
12
Owen Burdell Hays
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.12.1.2]
b. 4 Jan 1912 d. 25 Oct 1996
12
Lavona Maybelle Hays
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.12.1.3]
b. 30 Jul 1917 d. 5 Jul 1982
11
Nellie Mary Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.12.2]
b. 3 Mar 1885 d. 6 Mar 1894
11
Bertha Helen Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.12.3]
b. 20 Apr 1886 d. 22 Nov 1946
+
Vern C Thompson
b. Abt 1884
11
Bert Thompson Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.12.4]
b. 2 Nov 1886 d. 10 Aug 1952
11
Winifred R Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.12.5]
b. 8 Dec 1887 d. 11 Mar 1896
11
Alfred Hiram Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.12.6]
b. 19 Nov 1889 d. 10 Aug 1955
Pearl Ethel Tuttle
b. 9 Oct 1901 d. 1 Aug 1985
12
Betty Jane Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.12.6.1]
b. 24 Jan 1927 d. 7 Jul 1992
11
Pearl Jane Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.12.7]
b. 10 Aug 1891 d. 24 Mar 1924
+
Ray McVay
b. Abt 1889
11
Nell Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.12.8]
b. Abt 1890
+
Rufus Bennett
b. 20 Nov 1888 d. 16 Jul 1961
11
Louella Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.12.9]
b. 6 Mar 1894
11
Francine Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.2.12.10]
b. 26 Sep 1895 d. 11 Apr 1966
+
Larry Hilmar
b. Abt 1893
9
John Farwell Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.3]
b. 2 Apr 1816 d. 21 Jun 1899
Elizabeth Maria Burdick
b. 16 Sep 1821 d. 28 Mar 1899
10
Maria Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.1]
b. 1842 d. Abt 1847
10
Byron Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.2]
b. 1844
10
Mary Jane Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.3]
b. 1845
10
Edwin Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.4]
b. 1847
10
Sarah Elizabeth Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.5]
b. 2 Jun 1849 d. 28 Aug 1937
Ephraim Easton Rosenberg
b. 10 Oct 1837 d. 18 Jan 1910
11
Ida Emma Rosenberg
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.5.1]
b. 22 Dec 1869 d. 8 Feb 1941
Gottlieb David Kunz
b. 17 Sep 1866 d. 2 Sep 1941
12
Sadie Beatrice Kunz
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.5.1.1]
b. 24 Nov 1892 d. 9 Mar 1983 [
=>
]
12
Laura Byrde Kunz
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.5.1.2]
b. 26 Mar 1894 d. 10 Mar 1965 [
=>
]
12
Hazel Marie Kunz
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.5.1.3]
b. 11 Dec 1895 d. 3 Oct 1978 [
=>
]
12
Arnold Samuel Kunz
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.5.1.4]
b. 5 Jun 1897 d. 15 Feb 1961 [
=>
]
12
Allan Dewey Kunz
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.5.1.5]
b. 17 Nov 1898 d. 26 Aug 1979 [
=>
]
11
Jennie Dora Rosenberg
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.5.2]
b. 22 Jan 1871 d. 28 Aug 1872
11
Bert Rosenberg
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.5.3]
b. 18 Sep 1876 d. 15 Dec 1943
Gertrude Bell Cummings
b. 3 Mar 1881 d. 2 Jun 1955
12
Walter Roland Rosenberg
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.5.3.1]
b. 26 Apr 1910 d. 9 Aug 1989
12
Dorothy Rosenberg
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.5.3.2]
b. Abt 1914
12
George Oliver Rosenberg
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.5.3.3]
b. 19 Aug 1915 d. 24 Dec 1943
12
Living
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.5.3.4]
11
Ephraim Rosenberg
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.5.4]
b. 1877
11
Hattie Blanch Rosenberg
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.5.5]
b. 14 Apr 1880 d. 17 Jul 1881
11
James Malcom Rosenberg
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.5.6]
b. 5 Sep 1882 d. Feb 1970
Ruby Noeller
b. 27 Feb 1884 d. Jan 1967
12
Ralph R Rosenberg
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.5.6.1]
b. 14 May 1902 d. Dec 1981 [
=>
]
12
Bert Gerald Rosenberg
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.5.6.2]
b. 24 Aug 1904 d. 1982 [
=>
]
12
Leah Rosenberg
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.5.6.3]
b. 21 Jul 1907
+
Charles Radermacher
b. Abt 1845
10
Catherine Minerva Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.6]
b. 8 Feb 1852 d. 1930
Ichabod Hawley
b. 1835 d. Mar 1880
11
Effa Mae Hawley
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.6.1]
b. 1869 d. 1870
11
Jennie B Hawley
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.6.2]
b. 1871 d. 1872
11
Emily J Hawley
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.6.3]
b. 1876 d. 1877
11
Claudia Luella Hawley
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.6.4]
b. 1 Aug 1878 d. 3 Sep 1964
Barton Earl Geater
b. 4 Mar 1882 d. 29 Mar 1950
12
Hildred May Geater
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.6.4.1]
b. 19 Apr 1901
12
Harold L Geater
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.6.4.2]
b. 24 Jan 1905 d. 25 Jan 1986
11
Bud Hawley
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.6.5]
b. 1880 d. 1889
11
Ichabod Adalbert Hawley
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.6.6]
b. 15 Aug 1880
10
Ida Matilda Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.7]
b. 9 Jun 1854 d. 13 Apr 1932
Fred Josephus Wilson
b. 25 Feb 1836 d. 24 Oct 1898
11
Alfred Nathaniel Wilson
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.7.1]
b. 13 Sep 1875 d. 25 Jul 1967
Florence Adaliza Culp
b. 16 Sep 1883 d. 26 Jan 1935
12
Eva Wilson
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.7.1.1]
b. 1901 d. 1910
12
Oscar Wilson
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.7.1.2]
b. 17 Jul 1903 d. Jan 1979
12
Walter Wilson
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.7.1.3]
b. 8 Feb 1907 d. 17 Nov 1988
12
Clifford Wilson
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.7.1.4]
b. 1910 d. 1920
12
Leland Wilson
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.7.1.5]
b. 20 Nov 1914 d. 23 Dec 1981
11
Frank Wasden Wilson
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.7.2]
b. 25 Nov 1877 d. 26 Jun 1938
Myrtle Bernice Sumner
b. 1 Jul 1883 d. 22 Jan 1957
12
Ivan Otis Wilson
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.7.2.1]
b. 24 May 1904 d. 21 Jan 1987 [
=>
]
12
Lee Earnest Wilson
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.7.2.2]
b. 28 Sep 1906
12
Clyde Harold Wilson
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.7.2.3]
b. 1 Dec 1907 d. 12 Mar 1989 [
=>
]
12
Sylvia Bernita Wilson
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.7.2.4]
b. 19 Dec 1909 d. 10 Oct 2004 [
=>
]
12
Lyle Lloyd Wilson
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.7.2.5]
b. 4 Aug 1917 d. 3 Feb 1992
11
Pearl Ann Wilson
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.7.3]
b. 8 Jun 1880 d. 4 Mar 1881
11
Albert Arthur Wilson
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.7.4]
b. 6 Apr 1882 d. Jan 1970
+
Effie Ann Fletcher
b. 16 Jun 1887 d. 12 Feb 1946
11
Lewis Bernard Wilson
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.7.5]
b. 26 Oct 1884
11
Myrtle Ida Wilson
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.7.6]
b. 17 Feb 1888 d. 20 Feb 1933
11
Minnie Elizabeth Wilson
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.7.7]
b. 9 Jul 1892
+
Nathaniel Smith Davidson
11
Jesse Bryan Wilson
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.7.8]
b. 22 Jul 1896 d. 24 Dec 1974
+
Lucell Henkle
b. 1900
10
John Burdick Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.8]
b. 15 Oct 1854 d. 2 Nov 1931
Ella Viola Woodard
b. 15 Oct 1853 d. 4 Apr 1933
11
Son Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.8.1]
b. 27 Aug 1882 d. Bef 1910
11
Capitola Elizabeth Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.8.2]
b. Abt 1888 d. 13 Apr 1931
+
John Fremont Criswell
b. 29 Jul 1887 d. 30 Nov 1957
11
Guy Edward Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.8.3]
b. 12 May 1891 d. 18 Oct 1968
Perna Helen Sheldon
b. 2 Feb 1894 d. 7 Jul 1973
12
Leland Leroy Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.8.3.1]
b. 2 Mar 1913 d. 29 Aug 1971
12
Ross Edward Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.8.3.2]
b. 25 Sep 1915 d. 30 May 2001
11
Ida May Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.8.4]
b. 16 Dec 1892
+
Frank Stevens
b. Abt 1888
11
Claudia Matilda Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.8.5]
b. 2 Jun 1895 d. 9 Dec 1972
+
Harold Eaton
b. Abt 1891
10
James Malcom Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.9]
b. 30 Mar 1859 d. 11 Nov 1919
10
Emma Adeline Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.10]
b. 18 Nov 1861 d. 26 Oct 1931
Charles Ernest Sumner
b. 26 Apr 1859 d. 27 Sep 1932
11
Myrtle Bernice Sumner
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.10.1]
b. 1 Jul 1883 d. 22 Jan 1957
Frank Wasden Wilson
b. 25 Nov 1877 d. 26 Jun 1938
12
Ivan Otis Wilson
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.10.1.1]
b. 24 May 1904 d. 21 Jan 1987 [
=>
]
12
Lee Earnest Wilson
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.10.1.2]
b. 28 Sep 1906
12
Clyde Harold Wilson
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.10.1.3]
b. 1 Dec 1907 d. 12 Mar 1989 [
=>
]
12
Sylvia Bernita Wilson
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.10.1.4]
b. 19 Dec 1909 d. 10 Oct 2004 [
=>
]
12
Lyle Lloyd Wilson
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.10.1.5]
b. 4 Aug 1917 d. 3 Feb 1992
10
Alvan Nathaniel Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.3.11]
b. Jul 1864 d. 22 Feb 1903
9
Derius Dagget
[1.1.1.1.4.4.3.5.4]
b. 9 Jan 1819 d. 30 Jan 1819
9
Sarah Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.5]
b. 31 Jul 1822 d. May 1922
9
Sophia Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.5.6]
b. 9 Oct 1825
+
James Monroe Sumner
b. 17 Mar 1817 d. 13 Jun 1873
8
Caleb C Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.6]
b. Abt 1790 d. 23 Dec 1879
8
Artemas Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.7]
b. 17 Jul 1790
8
Mary Daggett
[1.1.1.1.4.4.3.8]
b. 10 Nov 1795 d. 18 Aug 1864
Henry C Hooker
b. 5 Jul 1791 d. 17 Mar 1885
9
Amelia Prentice Hooker
[1.1.1.1.4.4.3.8.1]
b. 26 Aug 1817 d. 23 Dec 1817
9
Julia Worthington Hooker
[1.1.1.1.4.4.3.8.2]
b. 15 Nov 1818 d. 14 Oct 1915
Henry Mason Jones
b. 24 Jul 1811 d. 7 Jul 1886
10
Henry Abbott Jones
[1.1.1.1.4.4.3.8.2.1]
b. 29 Mar 1845
10
Charles Armest Jones
[1.1.1.1.4.4.3.8.2.2]
b. 25 Feb 1848
+
Emily Cornelia French
b. 26 Mar 1852
10
Frederick Hooker Jones
[1.1.1.1.4.4.3.8.2.3]
b. 30 Nov 1866
Alice Mabel Spencer
b. 1873
11
George Frederick Jones
[1.1.1.1.4.4.3.8.2.3.1]
b. 18 Apr 1897
9
George Prentice Hooker
[1.1.1.1.4.4.3.8.3]
b. 31 May 1820 d. 1912
Lucretia Jane Ashcraft
b. 1822 d. 25 Feb 1897
10
Della Louise Hooker
[1.1.1.1.4.4.3.8.3.1]
b. 23 Jul 1844
+
Winchester S Puffer
b. 18 May 1840
10
Augusta R Hooker
[1.1.1.1.4.4.3.8.3.2]
b. 12 Oct 1851
Wolfred N Pike
b. 1858
11
George Hooker Pike
[1.1.1.1.4.4.3.8.3.2.1]
b. 19 Sep 1885
11
Mabel Josephine Pike
[1.1.1.1.4.4.3.8.3.2.2]
b. 24 May 1887
10
George Utley Hooker
[1.1.1.1.4.4.3.8.3.3]
b. 9 Oct 1856 d. 13 Jan 1858
10
Cora Jane Hooker
[1.1.1.1.4.4.3.8.3.4]
b. 10 Jan 1859
+
Gustave Samuel Smith
9
Charles Gay Hooker
[1.1.1.1.4.4.3.8.4]
b. 12 Nov 1822 d. 18 Nov 1905
Maria Celia Osgood
b. 3 Sep 1836
10
Charles Osgood Hooker
[1.1.1.1.4.4.3.8.4.1]
b. 10 Aug 1860
Ella Wall Goad
b. 19 Sep 1868 d. 11 Nov 1947
11
Osgood Hooker
[1.1.1.1.4.4.3.8.4.1.1]
b. 6 Aug 1897
10
Robert Gay Hooker
[1.1.1.1.4.4.3.8.4.2]
b. 13 Jul 1862
10
Jennie May Hooker
[1.1.1.1.4.4.3.8.4.3]
b. 3 Jul 1864
10
Bessie Augusta Hooker
[1.1.1.1.4.4.3.8.4.4]
b. 31 Dec 1868
10
Florence Gertrude Hooker
[1.1.1.1.4.4.3.8.4.5]
b. 1 Apr 1871
9
Ansen Carey Hooker
[1.1.1.1.4.4.3.8.5]
b. 2 Sep 1825 d. 4 Jul 1832
9
Henry Clay Hooker
[1.1.1.1.4.4.3.8.6]
b. 10 Jan 1828 d. 5 Dec 1907
Elizabeth Tewksbury Rockwell
b. 23 Dec 1837 d. 14 Mar 1915
10
Ida M Hooker
[1.1.1.1.4.4.3.8.6.1]
b. 3 May 1858
10
Edwin R Hooker
[1.1.1.1.4.4.3.8.6.2]
b. 27 Feb 1861
10
Joseph M Hooker
[1.1.1.1.4.4.3.8.6.3]
b. 4 Sep 1863
+
Laura Butler Coffin
b. 1885
9
Almira Ann Hooker
[1.1.1.1.4.4.3.8.7]
b. 28 May 1830 d. 5 Jul 1904
Isaiah Hall Nutting
b. 14 Dec 1824 d. 1 Dec 1865
10
Frederic Joseph Nutting
[1.1.1.1.4.4.3.8.7.1]
b. 22 Nov 1854
Annie Wheatley
b. 24 Aug 1851
11
Eva Winnefred Nutting
[1.1.1.1.4.4.3.8.7.1.1]
b. 7 Nov 1875
11
Minnie Estelle Nutting
[1.1.1.1.4.4.3.8.7.1.2]
b. 9 Sep 1878
10
Herbert Hooker Nutting
[1.1.1.1.4.4.3.8.7.2]
b. 22 Jul 1859 d. 7 Jul 1947
Loretta Ann McCoy
b. 2 Aug 1860
11
Walter Hull Nutting
[1.1.1.1.4.4.3.8.7.2.1]
b. 4 Mar 1886 d. 7 Dec 1931
11
Almira Elizabeth Nutting
[1.1.1.1.4.4.3.8.7.2.2]
b. 21 Oct 1888 d. 31 Jan 1956
Charles Edgar Kennedy
b. 19 Feb 1882 d. 5 Aug 1949
12
Kenneth Ray Kennedy
[1.1.1.1.4.4.3.8.7.2.2.1]
b. 26 Oct 1919 d. 2 Mar 2004
12
Eleanor Louise Kennedy
[1.1.1.1.4.4.3.8.7.2.2.2]
b. 25 Apr 1924 d. 14 Mar 2003 [
=>
]
11
Clara May Nutting
[1.1.1.1.4.4.3.8.7.2.3]
b. 28 Jan 1891 d. 21 Oct 1892
11
Minnie Ber Chambers
[1.1.1.1.4.4.3.8.7.2.4]
b. 2 Jun 1892 d. 15 Mar 1973
Francis Chambers
b. 8 Aug 1876 d. 12 Jul 1963
12
Clifford Chambers
[1.1.1.1.4.4.3.8.7.2.4.1]
b. 8 Dec 1912 d. 26 Aug 1998
12
Edward F Chambers
[1.1.1.1.4.4.3.8.7.2.4.2]
b. 25 May 1916 d. 27 Sep 1989
10
Minnie Mariah Nutting
[1.1.1.1.4.4.3.8.7.3]
b. 4 Aug 1861
9
Minerva Sophia Hooker
[1.1.1.1.4.4.3.8.8]
b. 11 Sep 1832 d. 13 Nov 1921
Robert Turnbull Brown
b. 1842 d. 19 Nov 1878
10
Robert Turnbull Brown
[1.1.1.1.4.4.3.8.8.1]
b. 31 Jul 1868
10
Minnie Isabel Brown
[1.1.1.1.4.4.3.8.8.2]
b. 19 Sep 1871 d. 22 Sep 1871
10
Edith Hooker Brown
[1.1.1.1.4.4.3.8.8.3]
b. 1 Jul 1872 d. 15 May 1873
+
Edwin Ruthven Robertson
b. 1828 d. 4 Apr 1902
9
Ansen Carey Hooker
[1.1.1.1.4.4.3.8.9]
b. 1 May 1835 d. 8 Nov 1915
9
John Daggett Hooker
[1.1.1.1.4.4.3.8.10]
b. 10 May 1838 d. 24 May 1911
Katharine Muzzy Putnam
b. 2 May 1849
10
Laurence Whitney Hooker
[1.1.1.1.4.4.3.8.10.1]
b. 14 Jun 1873 d. 11 Dec 1894
10
Marian Osgood Hooker
[1.1.1.1.4.4.3.8.10.2]
b. 15 Jul 1875
9
Mary Rosella Hooker
[1.1.1.1.4.4.3.8.11]
b. 12 Jan 1841 d. May 1925
+
Nicholas H. Smith
b. 1839
7
Gideon Daggett
[1.1.1.1.4.4.4]
b. 21 Dec 1759 d. 27 Aug 1838
Elizabeth Pratt
b. 22 Jul 1759 d. 1822
8
Gardner Daggett
[1.1.1.1.4.4.4.1]
b. 12 Oct 1788 d. Oct 1843
Eunice White
b. 23 Oct 1787 d. 15 Jun 1833
9
Sophronia Daggett
[1.1.1.1.4.4.4.1.1]
b. 15 Jul 1812 d. 14 Oct 1888
+
Amos Stoddard
9
Diana Daggett
[1.1.1.1.4.4.4.1.2]
b. Dec 1814 d. 1866
9
Eunice Daggett
[1.1.1.1.4.4.4.1.3]
b. Dec 1816 d. 1841
9
Elizabeth Ann Daggett
[1.1.1.1.4.4.4.1.4]
b. 4 Jul 1818
9
William Daggett
[1.1.1.1.4.4.4.1.5]
b. 1821 d. May 1835
9
Gardner Daggett
[1.1.1.1.4.4.4.1.6]
b. Abt 1823
9
Arthur Daggett
[1.1.1.1.4.4.4.1.7]
b. Abt 1825
9
Harriet Daggett
[1.1.1.1.4.4.4.1.8]
b. Apr 1827 d. Oct 1876
Hays G. Luce
b. 1818
10
Emma Melissa Luce
[1.1.1.1.4.4.4.1.8.1]
b. Abt 1849
10
Sarah Luce
[1.1.1.1.4.4.4.1.8.2]
b. Abt 1851
10
Harriet Luce
[1.1.1.1.4.4.4.1.8.3]
b. Abt 1853
10
John Luce
[1.1.1.1.4.4.4.1.8.4]
b. 18 May 1854 d. 4 Feb 1922
Mary Hayes
b. 1854 d. 1942
11
Leanora May Luce
[1.1.1.1.4.4.4.1.8.4.1]
b. 5 Apr 1878
11
Orrin Oscar Luce
[1.1.1.1.4.4.4.1.8.4.2]
b. 15 Mar 1880
10
Moses Luce
[1.1.1.1.4.4.4.1.8.5]
b. Abt 1857
10
Emily Luce
[1.1.1.1.4.4.4.1.8.6]
b. Abt 1859
9
Ester Smith Daggett
[1.1.1.1.4.4.4.1.9]
b. 27 Sep 1829
Edward Henry Gleason
b. 12 Dec 1823 d. 24 Nov 1889
10
Rollin Henry Gleason
[1.1.1.1.4.4.4.1.9.1]
b. 24 Dec 1854 d. 28 Sep 1918
Lura Bell Lease
b. 26 Mar 1857 d. Apr 1921
11
Gertrude Gleason
[1.1.1.1.4.4.4.1.9.1.1]
b. 18 Sep 1880
11
Grace Gleason
[1.1.1.1.4.4.4.1.9.1.2]
b. 8 Jun 1883 d. 8 Aug 1952
William Dominic Hummer
b. 5 Mar 1885 d. 25 Nov 1940
12
Robert Frederick Hummer
[1.1.1.1.4.4.4.1.9.1.2.1]
b. 26 Jan 1911 d. 9 Oct 1998
12
Charles Albert Hummer
[1.1.1.1.4.4.4.1.9.1.2.2]
b. 27 Aug 1919 d. 3 Nov 1951
11
Lura Gleason
[1.1.1.1.4.4.4.1.9.1.3]
b. 16 May 1885 d. 4 Aug 1941
+
Victor Holmes
11
Ruth Gleason
[1.1.1.1.4.4.4.1.9.1.4]
b. 17 Feb 1887 d. 31 Oct 1952
+
Claude Winn
11
Esther Gleason
[1.1.1.1.4.4.4.1.9.1.5]
b. 19 May 1889
+
Harry Fording
11
Rollin Gleason
[1.1.1.1.4.4.4.1.9.1.6]
b. 4 May 1892 d. Jan 1928
10
Irene May Gleason
[1.1.1.1.4.4.4.1.9.2]
b. 3 Feb 1858 d. 24 Feb 1858
10
Emie Bell Gleason
[1.1.1.1.4.4.4.1.9.3]
b. 10 May 1860 d. 1 Apr 1886
10
Stanley Gleason
[1.1.1.1.4.4.4.1.9.4]
b. 31 Jan 1863 d. 30 Mar 1863
10
Adrienna Gleason
[1.1.1.1.4.4.4.1.9.5]
b. 1 May 1864
10
Grace Gleason
[1.1.1.1.4.4.4.1.9.6]
b. 8 Oct 1866 d. 12 Aug 1868
10
Helen Gleason
[1.1.1.1.4.4.4.1.9.7]
b. 13 Nov 1869 d. 30 Jun 1883
10
Maud Gleason
[1.1.1.1.4.4.4.1.9.8]
b. 28 Feb 1873 d. 11 Aug 1874
10
Claud Gleason
[1.1.1.1.4.4.4.1.9.9]
b. 28 Feb 1873
9
Rollin Mallory Daggett
[1.1.1.1.4.4.4.1.10]
b. 22 Feb 1831
+
Maggie Curry
b. 19 Mar 1851 d. 21 Mar 1877
+
Lizzie Mabel Hinds
b. 12 Apr 1863
8
William King Daggett
[1.1.1.1.4.4.4.2]
b. 24 Aug 1792 d. 6 Feb 1862
+
Betsy Johnson
b. 20 Sep 1791 d. 6 Nov 1835
8
Nancy Daggett
[1.1.1.1.4.4.4.3]
b. 1793
8
Harvey Daggett
[1.1.1.1.4.4.4.4]
b. 1797
8
Gideon Daggett
[1.1.1.1.4.4.4.5]
b. 1800
7
Betty Daggett
[1.1.1.1.4.4.5]
b. 3 Feb 1763 d. 28 Jul 1829
Thomas Todd
b. 17 Nov 1760 d. 20 Nov 1848
8
Billy Todd
[1.1.1.1.4.4.5.1]
b. 15 Jul 1783 d. 1871
8
Lavina Todd
[1.1.1.1.4.4.5.2]
b. 1 Sep 1785 d. Mar 1835
8
Orinda Todd
[1.1.1.1.4.4.5.3]
b. 1 Sep 1787 d. 12 Jun 1872
Jeremiah Dewey
b. 31 Jan 1788 d. 29 Jul 1849
9
Harvey Dewey
[1.1.1.1.4.4.5.3.1]
b. 1814
9
Elizabeth "Betsey" Dewey
[1.1.1.1.4.4.5.3.2]
b. 6 Apr 1814 d. 6 Apr 1848
William Van Benschoten
b. 28 Dec 1806 d. 1 Dec 1863
10
Eulalia Carlin Van Benschoten
[1.1.1.1.4.4.5.3.2.1]
b. 9 Feb 1834 d. 9 Jul 1898
John Decatur Peterson
b. 26 Feb 1841 d. 27 May 1910
11
Carlin Eulalia Peterson
[1.1.1.1.4.4.5.3.2.1.1]
b. 23 Oct 1864 d. 28 May 1951
Edward Frank Collins
b. Dec 1856 d. 12 Jan 1902
12
Lee Sanford Collins
[1.1.1.1.4.4.5.3.2.1.1.1]
b. 18 Dec 1885 d. 16 May 1946
12
William Peterson Collins
[1.1.1.1.4.4.5.3.2.1.1.2]
b. 4 Jul 1887 d. 29 Aug 1945
12
Richard Kent Collins
[1.1.1.1.4.4.5.3.2.1.1.3]
b. 7 Jul 1895 d. 10 Aug 1978
11
William John Petersen
[1.1.1.1.4.4.5.3.2.1.2]
b. 6 Nov 1866 d. 6 Sep 1886
11
Eva Restoria Petersen
[1.1.1.1.4.4.5.3.2.1.3]
b. 12 Mar 1870 d. 29 Apr 1871
11
Betsy Anna Peterson
[1.1.1.1.4.4.5.3.2.1.4]
b. 12 Sep 1871 d. 21 Mar 1939
Peter J LaVoo
b. 14 Oct 1863 d. 13 Aug 1898
12
Dorothy Vesta LaVoo
[1.1.1.1.4.4.5.3.2.1.4.1]
b. 24 Oct 1888 d. 7 Jan 1987 [
=>
]
12
Bessie LaVoo
[1.1.1.1.4.4.5.3.2.1.4.2]
b. 10 Sep 1897
Stephen Ezra Meeker
b. 6 Dec 1872 d. 9 Feb 1928
12
Allen Freeborn Meeker
[1.1.1.1.4.4.5.3.2.1.4.3]
b. 2 Nov 1908 d. 13 Dec 1964
11
Jane Van Benschoten "Jennie" Petersen
[1.1.1.1.4.4.5.3.2.1.5]
b. 3 May 1873 d. 14 Sep 1935
Alvin Frank Klasen
b. 17 Feb 1872 d. 1 Sep 1950
12
Martin John Klasen
[1.1.1.1.4.4.5.3.2.1.5.1]
b. 23 Oct 1904 d. 1904
12
Virginia Josephine Klasen
[1.1.1.1.4.4.5.3.2.1.5.2]
b. 27 Dec 1905 d. 6 Sep 1984
12
Agnes Jane Klasen
[1.1.1.1.4.4.5.3.2.1.5.3]
b. 16 Apr 1907 d. 29 May 1993
11
Hiram Dewey Peterson
[1.1.1.1.4.4.5.3.2.1.6]
b. 1 Jan 1876 d. 19 Aug 1923
Martha Ellen Cleveland
b. 16 Jul 1875 d. 24 May 1958
12
Eulalia Carlin Peterson
[1.1.1.1.4.4.5.3.2.1.6.1]
b. 22 Jan 1903 d. 1995 [
=>
]
12
Mary Alice Peterson
[1.1.1.1.4.4.5.3.2.1.6.2]
b. 31 Mar 1905 d. 16 Apr 1992
12
Clara Jeannetta "Jeanne" Peterson
[1.1.1.1.4.4.5.3.2.1.6.3]
b. 19 Jan 1908 d. 23 Jul 1990
12
Martha Jane "Peggy" Peterson
[1.1.1.1.4.4.5.3.2.1.6.4]
b. 1 Feb 1916 d. 26 Jan 1997
11
Walter Lee Petersen
[1.1.1.1.4.4.5.3.2.1.7]
b. 6 Jul 1878 d. 8 Jul 1878
10
William W Van Benschoten
[1.1.1.1.4.4.5.3.2.2]
b. 12 Mar 1836 d. 15 Sep 1837
10
Marion E Van Benschoten
[1.1.1.1.4.4.5.3.2.3]
b. 14 Oct 1839 d. 25 Jul 1849
10
Helen Marr Van Benschoten
[1.1.1.1.4.4.5.3.2.4]
b. 28 Feb 1841 d. 26 Jul 1849
10
Frank Van Benschoten
[1.1.1.1.4.4.5.3.2.5]
b. 17 Jul 1844 d. 20 Sep 1847
10
Elizabeth A Van Benschoten
[1.1.1.1.4.4.5.3.2.6]
b. 24 Jan 1846 d. 8 Sep 1846
10
Elmore T Van Benschoten
[1.1.1.1.4.4.5.3.2.7]
b. 21 Jul 1847 d. Abt 1848
9
Hiram T Dewey
[1.1.1.1.4.4.5.3.3]
b. 13 Jul 1816 d. 25 May 1898
Susan Lanfley Stapleford
b. 28 Dec 1818 d. 25 May 1898
10
Jeremiah Todd Dewey
[1.1.1.1.4.4.5.3.3.1]
b. 7 Sep 1841
Laura Zaphia Henderson
11
George Lincoln Dewey
[1.1.1.1.4.4.5.3.3.1.1]
b. 8 Mar 1866 d. 20 Mar 1928
Hermine S
b. Abt 1874
12
Frank Osborne Dewey
[1.1.1.1.4.4.5.3.3.1.1.1]
b. Abt 1893
12
Arla Dewey
[1.1.1.1.4.4.5.3.3.1.1.2]
b. Abt 1894
12
Huldah Dewey
[1.1.1.1.4.4.5.3.3.1.1.3]
b. 19 Jun 1900 d. 12 Apr 1922
11
Frank H Dewey
[1.1.1.1.4.4.5.3.3.1.2]
b. Abt 1868 d. Bef 1880
11
Ella May Dewey
[1.1.1.1.4.4.5.3.3.1.3]
b. Abt 1871
10
George Eugene Dewey
[1.1.1.1.4.4.5.3.3.2]
b. 19 Dec 1843
Frances Amelia Cameron
b. 28 Jan 1852 d. 6 Mar 1889
11
William Hiram Dewey
[1.1.1.1.4.4.5.3.3.2.1]
b. 7 Mar 1886 d. 13 Dec 1951
Winnie Belle Harman
b. 29 Aug 1887 d. 9 Feb 1969
12
Muriel Harman Dewey
[1.1.1.1.4.4.5.3.3.2.1.1]
b. 18 Aug 1913 d. 22 Sep 1916
12
Winifred Cameron Dewey
[1.1.1.1.4.4.5.3.3.2.1.2]
b. 30 Jul 1915 d. 6 Jun 1973
12
William Hiram Dewey, Jr
[1.1.1.1.4.4.5.3.3.2.1.3]
b. 17 Nov 1919 d. 28 Nov 1919
12
Gloria Dewey
[1.1.1.1.4.4.5.3.3.2.1.4]
b. 6 Jun 1923 d. 6 Jun 1923
11
George Francis Dewey
[1.1.1.1.4.4.5.3.3.2.2]
b. 11 Jul 1877
11
Ralph Cameron Dewey
[1.1.1.1.4.4.5.3.3.2.3]
b. 18 Nov 1880
11
Julia Loise Dewey
[1.1.1.1.4.4.5.3.3.2.4]
b. 27 Oct 1884
10
Mary Elizabeth Dewey
[1.1.1.1.4.4.5.3.3.3]
b. 17 Mar 1846
Warren H Doolittle
11
May Doolittle
[1.1.1.1.4.4.5.3.3.3.1]
b. Abt 1873
11
Lillian Doolittle
[1.1.1.1.4.4.5.3.3.3.2]
b. Abt 1874
11
Harry Doolittle
[1.1.1.1.4.4.5.3.3.3.3]
b. Abt 1876
10
Susan Arabella Dewey
[1.1.1.1.4.4.5.3.3.4]
b. 26 Jul 1848
William Douglas Ainslie
11
Cora Ainslie
[1.1.1.1.4.4.5.3.3.4.1]
b. Abt 1870
11
Lola Ainslie
[1.1.1.1.4.4.5.3.3.4.2]
b. Abt 1873
11
Ned Ainslie
[1.1.1.1.4.4.5.3.3.4.3]
b. Abt 1875
11
Susan Ainslie
[1.1.1.1.4.4.5.3.3.4.4]
b. 21 Sep 1879
11
Hiram Dewey Ainslie
[1.1.1.1.4.4.5.3.3.4.5]
b. 3 Nov 1882
Elizabeth
b. Abt 1889
12
Donald Bedell Ainslie
[1.1.1.1.4.4.5.3.3.4.5.1]
b. Abt 1908 d. 1953
10
Hiram Stapleford Dewey
[1.1.1.1.4.4.5.3.3.5]
b. 3 Jul 1857 bur. 12 May 1934
Sophia Matilda Bradford
b. 1 Nov 1856
11
Seth Bradford "Brad" Dewey
[1.1.1.1.4.4.5.3.3.5.1]
b. 28 Feb 1882 d. 26 Aug 1938
Nellie Trinette Graef
b. 5 Nov 1884 d. 29 Mar 1952
12
Trinette Royce Dewey
[1.1.1.1.4.4.5.3.3.5.1.1]
b. 31 Jul 1906 d. 22 Sep 1970
12
Hiram Todd Dewey
[1.1.1.1.4.4.5.3.3.5.1.2]
b. 30 Nov 1908 d. 3 Nov 1951
12
Seth Bradford Dewey, Jr
[1.1.1.1.4.4.5.3.3.5.1.3]
b. 13 Sep 1913 d. 26 Jan 1970
12
Edward Stapleford Dewey
[1.1.1.1.4.4.5.3.3.5.1.4]
b. 11 May 1920 d. 11 Feb 2005
12
Thomas T "Tom" Dewey
[1.1.1.1.4.4.5.3.3.5.1.5]
b. 10 Jan 1924 d. 11 Nov 1994
11
Hiram Todd Dewey
[1.1.1.1.4.4.5.3.3.5.2]
b. 12 Mar 1884 d. 20 Jun 1884
10
William Henry Dewey
[1.1.1.1.4.4.5.3.3.6]
b. 1 Jan 1863 d. Dec
+
Harriet C Booth
9
Washington Dewey
[1.1.1.1.4.4.5.3.4]
b. 10 Sep 1818 d. 16 Mar 1896
Alvina Webster
b. 23 May 1818 d. 22 Oct 1871
10
Rosa M Dewey
[1.1.1.1.4.4.5.3.4.1]
b. Abt 1844
George W Jones
b. Abt 1839
11
George Jones
[1.1.1.1.4.4.5.3.4.1.1]
b. Abt 1867
11
Irving P Jones
[1.1.1.1.4.4.5.3.4.1.2]
b. Abt 1870
11
Rosa M Jones
[1.1.1.1.4.4.5.3.4.1.3]
b. Abt 1877
10
Royal E Dewey
[1.1.1.1.4.4.5.3.4.2]
b. 25 Aug 1849 d. 27 Dec 1907
Mary Pride
b. 1855
11
Edward Dewey
[1.1.1.1.4.4.5.3.4.2.1]
b. Abt 1874
11
Mabel Dewey
[1.1.1.1.4.4.5.3.4.2.2]
b. Abt 1876
10
George Washington Dewey
[1.1.1.1.4.4.5.3.4.3]
b. Abt 1853
10
Kate L Dewey
[1.1.1.1.4.4.5.3.4.4]
b. Abt 1856
9
Royal Dewey
[1.1.1.1.4.4.5.3.5]
b. 1820
9
Orinda Dewey
[1.1.1.1.4.4.5.3.6]
b. 1822
8
Diantha Todd
[1.1.1.1.4.4.5.4]
b. 1 May 1791 d. 27 Dec 1824
8
Elmer Todd
[1.1.1.1.4.4.5.5]
b. 16 Jun 1793 d. 13 Oct 1812
8
Relief Todd
[1.1.1.1.4.4.5.6]
b. 11 Mar 1798 d. 19 Oct 1885
Joseph Moulton
b. 7 Feb 1798 d. 10 Feb 1873
9
Anne Moulton
[1.1.1.1.4.4.5.6.1]
b. 31 Mar 1822
Charles Cowles
b. 19 Dec 1817 d. 28 Feb 1869
10
Joseph Moulton Cowles
[1.1.1.1.4.4.5.6.1.1]
b. 30 Jul 1848 d. 31 Dec 1850
10
Harriet Anne Cowles
[1.1.1.1.4.4.5.6.1.2]
b. 1 Sep 1850
10
Martha Chase Cowles
[1.1.1.1.4.4.5.6.1.3]
b. 3 Nov 1852
10
Chester William Cowles
[1.1.1.1.4.4.5.6.1.4]
b. 7 Dec 1854 d. 7 May 1858
10
Charlotte Cowles
[1.1.1.1.4.4.5.6.1.5]
b. 27 Jan 1859
William Henry Ober
b. 1857 d. 2 Mar 1885
11
Mildred Ruth Ober
[1.1.1.1.4.4.5.6.1.5.1]
b. 14 Sep 1883 d. 25 Apr 1895
10
Charles Albert Cowles
[1.1.1.1.4.4.5.6.1.6]
b. 12 May 1862
Lettie Estelle Ford
b. 28 Apr 1861
11
Charles Leon Cowles
[1.1.1.1.4.4.5.6.1.6.1]
b. 31 Jan 1891
+
Cora May Parsons
b. 9 Dec 1888
9
James Thompson Moulton
[1.1.1.1.4.4.5.6.2]
b. 1 Nov 1823
Louisa J Williams
b. 28 Dec 1822 d. 12 Apr 1871
10
Catherine Elizabeth Moulton
[1.1.1.1.4.4.5.6.2.1]
b. 26 Jan 1852
10
Joseph Moulton
[1.1.1.1.4.4.5.6.2.2]
b. 5 Feb 1854
Emma Gertrude Addie Pool
b. 4 Nov 1862
11
Louise Margaret Moulton
[1.1.1.1.4.4.5.6.2.2.1]
b. 13 Mar 1889
10
David W Moulton
[1.1.1.1.4.4.5.6.2.3]
b. 9 Nov 1855 d. 27 Jun 1937
+
Marceline L Bunton
b. 2 Sep 1860
10
Abbie Louisa Moulton
[1.1.1.1.4.4.5.6.2.4]
b. 1 May 1857
10
James Thompson Moulton
[1.1.1.1.4.4.5.6.2.5]
b. 18 Mar 1859 d. 10 Jul 1859
10
Anna Moulton
[1.1.1.1.4.4.5.6.2.6]
b. 10 Apr 1860 d. 13 May 1862
10
Annette Frances Moulton
[1.1.1.1.4.4.5.6.2.7]
b. 21 Nov 1862
10
John Franklin Moulton
[1.1.1.1.4.4.5.6.2.8]
b. 1 Jan 1866 d. 15 Aug 1894
+
Helen Ewell
b. 20 Jul 1822 d. 27 Jan 1909
9
Charles Henry Moulton
[1.1.1.1.4.4.5.6.3]
b. 6 Feb 1829
Lydia S Wiley
b. Abt 1830
10
Mary Ellen Moulton
[1.1.1.1.4.4.5.6.3.1]
b. 20 Apr 1856
9
John Todd Moulton
[1.1.1.1.4.4.5.6.4]
b. 7 Aug 1838 d. 10 Feb 1873
Sarah Frances Sweetser
b. 20 Jun 1841 d. 24 Apr 1918
10
Annie Coules Moulton
[1.1.1.1.4.4.5.6.4.1]
b. 5 Dec 1867
Charles E Haywood
b. Oct 1868 d. Dec 1972
11
Richard Mansfield Haywood
[1.1.1.1.4.4.5.6.4.1.1]
b. 1905
11
Henry Stewart Haywood
[1.1.1.1.4.4.5.6.4.1.2]
b. 29 Dec 1906 d. Aug 1977
10
Albert S Moulton
[1.1.1.1.4.4.5.6.4.2]
b. 31 Jul 1872 d. 15 Sep 1943
Grace E Lufkin
b. 1 Jan 1882 d. 14 Mar 1928
11
Robert Lufkin Moulton
[1.1.1.1.4.4.5.6.4.2.1]
b. 7 Mar 1909 d. 18 Sep 1949
+
Florence Mae Kirker
b. 17 Sep 1906 d. 19 Nov 1980
10
Robert Elmer Moulton
[1.1.1.1.4.4.5.6.4.3]
b. 15 Jan 1876 d. 3 Sep 1876
10
Elizabeth Jane Moulton
[1.1.1.1.4.4.5.6.4.4]
b. 28 Aug 1878
+
Thomas C Christie
10
Bessie Jane Moulton
[1.1.1.1.4.4.5.6.4.5]
b. 28 Aug 1878
9
Walter Scott Moulton
[1.1.1.1.4.4.5.6.5]
b. 9 Aug 1840 d. 17 Jun 1874
Rosalinda E. Wilson
b. May 1848
10
Relief Esther Moulton
[1.1.1.1.4.4.5.6.5.1]
b. 14 Jun 1868
Everett H Day
b. Feb 1870
11
Rosalinda Ellen Day
[1.1.1.1.4.4.5.6.5.1.1]
b. 11 Mar 1892 d. 16 Mar 1978
Milton Oliver Hudson
b. 13 Aug 1891 d. 22 Jan 1932
12
Joseph Everett Hudson
[1.1.1.1.4.4.5.6.5.1.1.1]
b. 16 Mar 1910 d. 19 Jun 1924
11
Earl M Day
[1.1.1.1.4.4.5.6.5.1.2]
b. Oct 1894
11
Maurice Herman Day
[1.1.1.1.4.4.5.6.5.1.3]
b. 3 Dec 1896
8
Alanson Todd
[1.1.1.1.4.4.5.7]
b. 5 Sep 1800 d. 13 Jul 1882
Lydia Wheeler
b. 24 Oct 1800 d. 14 Oct 1877
9
Elmor Todd
[1.1.1.1.4.4.5.7.1]
b. 27 Feb 1828 d. 16 Jul 1829
9
Son Todd
[1.1.1.1.4.4.5.7.2]
b. 4 Jul 1829 d. 4 Jul 1829
9
Cornelia Todd
[1.1.1.1.4.4.5.7.3]
b. 15 May 1831 d. 14 Mar 1877
+
Julius Leonard Stacey
b. 16 Oct 1826 d. 7 Nov 1902
9
Cyrus Wheeler Todd
[1.1.1.1.4.4.5.7.4]
b. 5 Jun 1833 d. 25 Dec 1903
Louisa Charlotte Hoese
d. 8 Mar 1926
10
William Irving Todd
[1.1.1.1.4.4.5.7.4.1]
b. 25 Aug 1873 d. 1 Dec 1942
+
Effie Gertrude Townsend
b. 30 Mar 1878 d. 28 Jan 1948
10
Helen May Todd
[1.1.1.1.4.4.5.7.4.2]
b. 3 May 1875
Ralph J Olson
b. Oct 1873
11
Thelma Lucille Olson
[1.1.1.1.4.4.5.7.4.2.1]
b. 21 Oct 1898
11
Plin Gifford Olson
[1.1.1.1.4.4.5.7.4.2.2]
b. 31 Aug 1900
11
Clara Frances Olson
[1.1.1.1.4.4.5.7.4.2.3]
b. 25 Dec 1901
11
Everett Clare "Lerch" Olson
[1.1.1.1.4.4.5.7.4.2.4]
b. 10 Feb 1907 d. 1942
+
Harry Raymond Trosper
b. 6 Jan 1884 d. 16 Dec 1926
10
Frank Hyrum Todd
[1.1.1.1.4.4.5.7.4.3]
b. 10 Sep 1883 d. 28 Jun 1958
Nellie Edith Farnham
b. 8 May 1889 d. 1 Aug 1978
11
Dr Frank Arnold Todd, DVM
[1.1.1.1.4.4.5.7.4.3.1]
b. 11 Sep 1911 d. 26 Feb 1995
Margaret Louise Clapp
b. 1 Apr 1912 d. Sep 1987
12
Thomas Todd
[1.1.1.1.4.4.5.7.4.3.1.1]
b. 3 Feb 1939 d. 6 Sep 2011
12
Living
[1.1.1.1.4.4.5.7.4.3.1.2]
11
Guy Harold Todd
[1.1.1.1.4.4.5.7.4.3.2]
b. 11 Sep 1911 d. 18 Jan 1966
+
Viola Magdalene Hauff
b. 16 Mar 1909 d. 28 May 1978
11
Helen Louise Todd
[1.1.1.1.4.4.5.7.4.3.3]
b. 8 May 1923 d. 10 Sep 1972
+
Frederick McKewon Smith
d. 19 Jan 1976
11
Gene William Todd
[1.1.1.1.4.4.5.7.4.3.4]
b. 28 Nov 1926 d. 10 Jan 1931
9
Hiram Todd
[1.1.1.1.4.4.5.7.5]
b. 30 Apr 1836 d. 20 Jun 1840
9
Helen Mar Todd
[1.1.1.1.4.4.5.7.6]
b. 1 Jul 1838 d. 27 Jan 1923
8
Charles Todd
[1.1.1.1.4.4.5.8]
b. 27 Sep 1802 d. 8 Apr 1804
8
Hiram Todd
[1.1.1.1.4.4.5.9]
b. 18 Nov 1795 d. 11 Jul 1849
Lydia Church
b. 8 Jan 1802 d. 26 Dec 1871
9
Caroline Todd
[1.1.1.1.4.4.5.9.1]
b. 26 Feb 1830 d. Mar 1833
9
Frances Todd
[1.1.1.1.4.4.5.9.2]
b. 12 Sep 1832
Rodney S Bowen
b. 1831 d. 3 Dec 1864
10
Mary C Bowen
[1.1.1.1.4.4.5.9.2.1]
b. Abt 1852
10
Rodney S Bowen
[1.1.1.1.4.4.5.9.2.2]
b. Abt 1854
10
Albert W Bowen
[1.1.1.1.4.4.5.9.2.3]
b. Abt 1856
10
Martha Bowen
[1.1.1.1.4.4.5.9.2.4]
b. Abt 1858
9
Hiram Church Todd
[1.1.1.1.4.4.5.9.3]
b. 26 Jun 1835
Sarah D Barnard
b. 2 Jan 1842 d. 2 Oct 1878
10
Maggie Barnard Todd
[1.1.1.1.4.4.5.9.3.1]
b. 21 Nov 1862 d. 25 Aug 1881
10
Walter Wilson Todd
[1.1.1.1.4.4.5.9.3.2]
b. 22 May 1865
Fannie Taylor Clarke
b. Abt 1869
11
Dorothy Clarke Todd
[1.1.1.1.4.4.5.9.3.2.1]
b. 17 Mar 1894
11
Thomas C Todd
[1.1.1.1.4.4.5.9.3.2.2]
b. 6 Oct 1897
10
Grace Lydia Todd
[1.1.1.1.4.4.5.9.3.3]
b. 18 Oct 1868 d. 30 Mar 1872
10
Lucia May Todd
[1.1.1.1.4.4.5.9.3.4]
b. 4 May 1873 d. 11 Mar 1874
10
Lillian Belle Todd
[1.1.1.1.4.4.5.9.3.5]
b. 8 Dec 1874 d. 7 Aug 1876
10
Frank Ransom Todd
[1.1.1.1.4.4.5.9.3.6]
b. 1 Mar 1877 d. 27 Sep 1877
9
Martha Todd
[1.1.1.1.4.4.5.9.4]
b. 21 Sep 1837 d. 1 Sep 1847
9
Walter Wilson Todd
[1.1.1.1.4.4.5.9.5]
b. 27 Feb 1840 d. 18 Oct 1899
Azenath M Gerard
b. 9 Nov 1844 d. 16 Dec 1895
10
Laura Todd
[1.1.1.1.4.4.5.9.5.1]
b. 4 Oct 1869
+
Webb Wilde Martin
b. 10 Jan 1872
10
Church Gerard Todd
[1.1.1.1.4.4.5.9.5.2]
b. 15 Jan 1871
+
Zaide Murphy
b. 1 Jan 1874
10
Hiram Eugene Todd
[1.1.1.1.4.4.5.9.5.3]
b. 10 Sep 1874
+
Bertha May Ferris
b. May 1878
9
Edgar Todd
[1.1.1.1.4.4.5.9.6]
b. Abt 1842
8
Solomon Todd
[1.1.1.1.4.4.5.10]
b. 15 Oct 1804 d. 17 Oct 1832
8
Betsey Todd
[1.1.1.1.4.4.5.11]
b. 8 Nov 1806
Austin Bruce
b. 19 Dec 1803
9
Frances Elizabeth Bruce
[1.1.1.1.4.4.5.11.1]
b. 6 Sep 1830 d. 27 Sep 1915
Boardman F Stafford
b. 23 Apr 1827 d. 21 Oct 1886
10
Christopher Boardman Stafford
[1.1.1.1.4.4.5.11.1.1]
b. Oct 1856 d. 1925
Emma Hulda Hopkins
b. 20 Sep 1855 d. 24 May 1924
11
Earl Christopher Stafford
[1.1.1.1.4.4.5.11.1.1.1]
b. 19 Sep 1892 d. 22 Apr 1960
Ethel Marie Leonard
b. 16 Aug 1897 d. 10 Apr 1955
12
Jean Claire Stafford
[1.1.1.1.4.4.5.11.1.1.1.1]
b. 15 May 1928 d. 13 Jul 2009
10
Dwight Bliss Stafford
[1.1.1.1.4.4.5.11.1.2]
b. 11 Jan 1860 d. 1936
+
Esther P Cobb
b. 28 Feb 1863
10
Palmer A Stafford
[1.1.1.1.4.4.5.11.1.3]
b. 1 Jun 1869
7
Tamar Daggett
[1.1.1.1.4.4.6]
b. 24 Mar 1767 d. 23 Oct 1820
Eliphalet Holman
b. Abt 1761 d. 30 May 1838
8
Catharine Holman
[1.1.1.1.4.4.6.1]
b. 3 Dec 1789 d. 11 Aug 1864
John Cummings
b. 2 May 1786 d. 30 Oct 1832
9
Lucy Daggett Cummings
[1.1.1.1.4.4.6.1.1]
b. 18 Feb 1808 d. 9 Apr 1818
9
Tamar Holman Cummings
[1.1.1.1.4.4.6.1.2]
b. 19 Sep 1810 d. 5 Nov 1830
9
Eliphalet H Cummings
[1.1.1.1.4.4.6.1.3]
b. 2 Dec 1813 d. 15 Nov 1875
Harriet Aldrich
b. 12 Jun 1822 d. 15 Dec 1852
10
Cordelia Ann Cummings
[1.1.1.1.4.4.6.1.3.1]
b. 15 Dec 1841 d. 15 Jan 1856
10
George Francis "Franklin" Cummings
[1.1.1.1.4.4.6.1.3.2]
b. 27 Sep 1842 d. 30 Mar 1891
Julia Maria Hopkins
b. 16 Jan 1840 d. 28 Feb 1888
11
Harriet Gould Cummings
[1.1.1.1.4.4.6.1.3.2.1]
b. 10 Jan 1869 d. Abt 1940
11
Mary Elizabeth Cummings
[1.1.1.1.4.4.6.1.3.2.2]
b. 8 Sep 1875 d. 6 Jun 1878
11
Charles Franklin Cummings
[1.1.1.1.4.4.6.1.3.2.3]
b. 28 Dec 1877 d. 29 Jan 1935
Pearl M Cleveland Newlin
b. 18 Oct 1881 d. 24 Jan 1967
12
Charles Francis Cummings
[1.1.1.1.4.4.6.1.3.2.3.1]
b. 28 Jul 1900 d. 3 Jan 1987 [
=>
]
12
George Harry Cummings
[1.1.1.1.4.4.6.1.3.2.3.2]
b. 1903 d. 1904
12
Hazel May Cummings
[1.1.1.1.4.4.6.1.3.2.3.3]
b. 30 Nov 1906 d. 1 Apr 1995 [
=>
]
12
Forrest Dale Cummings
[1.1.1.1.4.4.6.1.3.2.3.4]
b. Abt 1916 d. Abt 1990
+
Sarah D Cummings
b. Abt 1820
9
Daniel Cummings
[1.1.1.1.4.4.6.1.4]
b. 15 May 1816 d. 15 Nov 1875
9
Preston Cummings
[1.1.1.1.4.4.6.1.5]
b. 10 Jun 1818 d. 14 Sep 1868
9
Lucy Cummings
[1.1.1.1.4.4.6.1.6]
b. 10 Oct 1819 d. 27 Sep 1821
9
Catharine Cummings
[1.1.1.1.4.4.6.1.7]
b. 1 Oct 1821 d. 27 Nov 1896
9
Diantha Cummings
[1.1.1.1.4.4.6.1.8]
b. 29 Mar 1823 d. 21 Sep 1860
9
John Cummings
[1.1.1.1.4.4.6.1.9]
b. 25 Dec 1824 d. 20 Jul 1898
9
Mary Cummings
[1.1.1.1.4.4.6.1.10]
b. 22 Jul 1827 d. 1904
9
Candace H Cummings
[1.1.1.1.4.4.6.1.11]
b. 1829
9
Lucy Tamar Cummings
[1.1.1.1.4.4.6.1.12]
b. 16 Oct 1831 d. 30 Sep 1833
5
Samuel Sibley
[1.1.1.1.5]
b. 16 May 1697 d. Dec 1730
Martha Dike
b. Abt 1700 d. 5 Oct 1775
6
Samuel Sibley
[1.1.1.1.5.1]
b. 1724 d. 31 Aug 1801
6
Nathaniel Sibley
[1.1.1.1.5.2]
b. Abt 1725 d. 24 May 1811
Ruth Bradish
b. 7 May 1722 d. 12 Aug 1810
7
Ruth Sibley
[1.1.1.1.5.2.1]
b. 9 Apr 1745 d. 30 Nov 1814
Benoni Benson
b. 11 Jul 1747 d. 1803
8
John Benson
[1.1.1.1.5.2.1.1]
b. 1789
7
Martha Sibley
[1.1.1.1.5.2.2]
b. 17 Apr 1747 d. 4 Mar 1775
7
Mary Sibley
[1.1.1.1.5.2.3]
b. 1 Sep 1749
7
Eunice Sibley
[1.1.1.1.5.2.4]
b. 27 Feb 1752 d. Mar 1775
7
Nathan Sibley
[1.1.1.1.5.2.5]
b. 22 Jun 1754 d. 22 Feb 1755
7
Stephen Sibley
[1.1.1.1.5.2.6]
b. 21 Sep 1756
7
Nathaniel Sibley
[1.1.1.1.5.2.7]
b. 20 Apr 1759 d. 25 Aug 1775
7
Jonas Sibley
[1.1.1.1.5.2.8]
b. 7 Mar 1762 d. 5 Feb 1834
6
Lucy Sibley
[1.1.1.1.5.3]
b. 16 Apr 1726 d. 13 Dec 1821
6
Jeremiah Sibley
[1.1.1.1.5.4]
b. 31 Dec 1728 d. Abt 1807
6
Benjamin Sibley
[1.1.1.1.5.5]
b. 27 Feb 1731 d. Aft 27 Jan 1794
5
William Sibley
[1.1.1.1.6]
c. 7 Sep 1700 d. 18 Sep 1763
Sarah
b. Abt 1703
6
William Sibley
[1.1.1.1.6.1]
b. 4 May 1727
6
Elijah Sibley
[1.1.1.1.6.2]
b. Abt 1728
6
Sarah Sibley
[1.1.1.1.6.3]
b. 23 Aug 1730 d. 13 Jun 1816
6
Daniel Sibley
[1.1.1.1.6.4]
b. 31 Jan 1732
6
David Sibley
[1.1.1.1.6.5]
b. 3 Oct 1736
5
Benjamin Sibley
[1.1.1.1.7]
b. 19 Sep 1703 d. 2 Nov 1780
Pricilla Rich
b. 28 Sep 1706 d. 1 Feb 1782
6
Priscilla Sibley
[1.1.1.1.7.1]
b. 5 Aug 1725 d. 6 Feb 1737
6
Benjamin Sibley, Jr
[1.1.1.1.7.2]
b. 17 Aug 1727 d. 12 Nov 1789
6
Zuruiah Sibley
[1.1.1.1.7.3]
b. 31 Aug 1729 d. Aft 1770
6
Susanna Sibley
[1.1.1.1.7.4]
b. 31 Aug 1733 d. 24 Apr 1810
6
Ezra Sibley
[1.1.1.1.7.5]
b. 4 Aug 1738 d. 11 Oct 1762
6
Aaron Sibley
[1.1.1.1.7.6]
b. 2 Jul 1740 d. 1776
6
Moses Sibley
[1.1.1.1.7.7]
b. 9 May 1743 d. 16 Sep 1760
6
Joseph Sibley
[1.1.1.1.7.8]
b. 19 Aug 1745
6
Samuel Sibley
[1.1.1.1.7.9]
b. 14 Jun 1747 d. 1841
6
Jonathan Sibley
[1.1.1.1.7.10]
b. 4 Mar 1750 d. 31 Jul 1828
3
Elizabeth Black
[1.1.2]
b. Abt 1632
Sir Humphrey Gilbert
b. 1616 d. Bef 30 Mar 1658
4
Martha Gilbert
[1.1.2.1]
b. Abt 1651 d. Bef 4 Feb 1692
4
Abigail Gilbert
[1.1.2.2]
b. Abt 1654 d. 1735
4
Esther Gilbert
[1.1.2.3]
b. 1654
4
John Gilbert
[1.1.2.4]
b. 1656 d. 17 Mar 1722
Elizabeth Kilham
b. 1657 d. 17 Mar 1722
5
Mary Gilbert
[1.1.2.4.1]
b. Abt 1681 d. 1681
5
Elizabeth Gilbert
[1.1.2.4.2]
b. Abt 1683
5
Daniel Gilbert
[1.1.2.4.3]
b. Abt 1685 d. 2 Nov 1723
Elisabeth Porter
b. Abt 1689 d. Jan 1789
6
Lydia Gilbert
[1.1.2.4.3.1]
b. 9 Dec 1711 d. Abt 1757
6
Mary Gilbert
[1.1.2.4.3.2]
b. 17 Sep 1721 d. 1760
6
Elizabeth Gilbert
[1.1.2.4.3.3]
c. 13 Nov 1713 d. 21 Aug 1751
Joseph Noyes
b. 14 Jul 1710 d. 1754
7
Elizabeth Noyes
[1.1.2.4.3.3.1]
b. 18 Dec 1735 d. 9 Jul 1829
Thomas Phillips
b. 7 Jun 1747 d. 9 Jul 1829
8
Rhoda Phillips
[1.1.2.4.3.3.1.1]
b. Abt 1770 d. 23 Nov 1825
Enoch King
b. 22 Jan 1770 d. 8 Oct 1853
9
Betsy King
[1.1.2.4.3.3.1.1.1]
b. 1789 d. 20 Mar 1863
9
Lydia King
[1.1.2.4.3.3.1.1.2]
b. Abt 1789 d. 16 May 1835
9
Lucy King
[1.1.2.4.3.3.1.1.3]
b. Abt 1789 d. 1790
9
Electa King
[1.1.2.4.3.3.1.1.4]
b. Abt 1791 d. Aft 1870
9
Otis King
[1.1.2.4.3.3.1.1.5]
b. 15 Mar 1793 d. 20 Mar 1863
9
Rachael King
[1.1.2.4.3.3.1.1.6]
b. Abt 1799 d. 1801
9
Polly Mary King
[1.1.2.4.3.3.1.1.7]
b. 18 Dec 1799 d. 28 Oct 1881
9
Moses King
[1.1.2.4.3.3.1.1.8]
b. 1803 d. 20 Mar 1863
9
Dorcas King
[1.1.2.4.3.3.1.1.9]
b. 3 May 1804 d. 6 Oct 1876
9
Thomas Jefferson King
[1.1.2.4.3.3.1.1.10]
b. 27 May 1806 d. 23 Sep 1876
Rebecca Englesby Olin
b. 30 Apr 1805 d. 12 Nov 1876
10
George Elisha King
[1.1.2.4.3.3.1.1.10.1]
b. 23 Oct 1828 d. 28 Oct 1855
Sabrina Curtis
b. 3 Apr 1829 d. 27 Jun 1890
11
David Abraham King
[1.1.2.4.3.3.1.1.10.1.1]
b. 21 Jan 1847 d. 18 Mar 1921
Anna Hannah Hicks
b. 8 Sep 1849 d. 9 Jun 1894
12
David Smith King
[1.1.2.4.3.3.1.1.10.1.1.1]
b. 28 May 1867 d. 25 Aug 1941 [
=>
]
12
Anna Larcena King
[1.1.2.4.3.3.1.1.10.1.1.2]
b. 23 Oct 1868 d. 2 Aug 1944 [
=>
]
12
William Henry King
[1.1.2.4.3.3.1.1.10.1.1.3]
b. 14 Oct 1870 d. 27 Feb 1957 [
=>
]
12
George King
[1.1.2.4.3.3.1.1.10.1.1.4]
b. 7 Apr 1875 d. 26 Dec 1954 [
=>
]
12
Sarah Elizabeth King
[1.1.2.4.3.3.1.1.10.1.1.5]
b. 28 Mar 1877 d. 26 Feb 1881
12
Celestia Ann King
[1.1.2.4.3.3.1.1.10.1.1.6]
b. 20 Apr 1879 d. 6 May 1970 [
=>
]
12
Rebecca Angelina King
[1.1.2.4.3.3.1.1.10.1.1.7]
b. 29 Mar 1881 d. 8 Aug 1913 [
=>
]
12
Son King
[1.1.2.4.3.3.1.1.10.1.1.8]
b. 1883 bur. 1883
12
Lydia King
[1.1.2.4.3.3.1.1.10.1.1.9]
b. 16 Oct 1884 d. 15 Nov 1978 [
=>
]
12
Silas Milo King
[1.1.2.4.3.3.1.1.10.1.1.10]
b. 5 Dec 1886 d. 1 Apr 1965 [
=>
]
12
Forrest Fountain King
[1.1.2.4.3.3.1.1.10.1.1.11]
b. 6 Jan 1889 d. 30 Oct 1956 [
=>
]
12
Walter King
[1.1.2.4.3.3.1.1.10.1.1.12]
b. 9 Mar 1892 d. 28 May 1902
11
Rebecca Angeline King
[1.1.2.4.3.3.1.1.10.1.2]
b. 1849 d. 1849
10
William Jefferson King
[1.1.2.4.3.3.1.1.10.2]
b. 13 Jul 1833 d. 26 Jun 1860
10
Jonathan Alma King
[1.1.2.4.3.3.1.1.10.3]
b. 2 Feb 1835 d. Dec 1849
10
Amy Jane King
[1.1.2.4.3.3.1.1.10.4]
b. 2 Oct 1836 d. 8 Nov 1913
Elias Smith
b. 6 Sep 1804 d. 24 Jun 1888
11
Silas Thomas Smith
[1.1.2.4.3.3.1.1.10.4.1]
b. 4 May 1857 d. 1 May 1945
11
Jesse Moroni Smith
[1.1.2.4.3.3.1.1.10.4.2]
b. 21 Nov 1858 d. 14 Mar 1937
+
Sarah Ann Smith
b. 11 Jul 1868 d. 2 Feb 1900
11
Rebecca Jane Smith
[1.1.2.4.3.3.1.1.10.4.3]
b. 23 Sep 1860 d. 18 Jul 1923
11
Mary Alzina Knapp Smith
[1.1.2.4.3.3.1.1.10.4.4]
b. 16 May 1865 d. 20 Jan 1953
11
Martha Priscilla Smith
[1.1.2.4.3.3.1.1.10.4.5]
b. 30 May 1865 d. 18 Apr 1946
11
Amy Esther Smith
[1.1.2.4.3.3.1.1.10.4.6]
b. 11 Aug 1867 d. 21 Sep 1910
11
Angelina Adelia Smith
[1.1.2.4.3.3.1.1.10.4.7]
b. 11 Jul 1869 d. 8 Mar 1950
11
Franklin Elias Smith
[1.1.2.4.3.3.1.1.10.4.8]
b. 13 Dec 1871 d. 24 Jul 1917
11
Sarah Susannah Smith
[1.1.2.4.3.3.1.1.10.4.9]
b. 26 Mar 1873 d. 25 Apr 1952
11
Hiram Bennett Smith
[1.1.2.4.3.3.1.1.10.4.10]
b. 2 Feb 1877 d. 29 Mar 1951
10
Rhoda Eleanor King
[1.1.2.4.3.3.1.1.10.5]
b. 3 Oct 1839 d. 5 Jul 1840
10
Enoch Elmer King
[1.1.2.4.3.3.1.1.10.6]
b. 3 Oct 1839 d. 20 Feb 1850
10
Thomas Franklin King
[1.1.2.4.3.3.1.1.10.7]
b. 1 May 1842 d. 8 Jan 1913
10
Rebecca Angelina King
[1.1.2.4.3.3.1.1.10.8]
b. 29 Jun 1845 d. 1 Dec 1908
9
Enoch Edwin King
[1.1.2.4.3.3.1.1.11]
b. 1808 d. 23 Sep 1886
9
John Russell King
[1.1.2.4.3.3.1.1.12]
b. 16 Oct 1810 d. 28 Feb 1877
9
Rhoda King
[1.1.2.4.3.3.1.1.13]
b. 1811
8
Mary Phillips
[1.1.2.4.3.3.1.2]
b. 1 Oct 1774 d. 20 Apr 1844
8
Rachael Phillips
[1.1.2.4.3.3.1.3]
b. 1777 d. 9 Mar 1864
8
Russel Phillips
[1.1.2.4.3.3.1.4]
b. 31 Aug 1785 d. 15 Apr 1856
8
Caleb Phillips
[1.1.2.4.3.3.1.5]
b. Abt 1787
8
Moses Phillips
[1.1.2.4.3.3.1.6]
b. Abt 1789
8
Betsey Phillips
[1.1.2.4.3.3.1.7]
b. 1789 d. 1813
8
Dorcas Phillips
[1.1.2.4.3.3.1.8]
b. Abt 1789
7
Mary Noyes
[1.1.2.4.3.3.2]
b. 28 Dec 1737
7
Daniel Noyes
[1.1.2.4.3.3.3]
b. 10 Jun 1740 d. Abt 1824
7
Moses Noyes
[1.1.2.4.3.3.4]
b. 11 May 1743
6
Mercy Gilbert
[1.1.2.4.3.4]
c. 1 Apr 1716
6
Daniel Gilbert
[1.1.2.4.3.5]
c. 13 Apr 1718
6
Hannah Gilbert
[1.1.2.4.3.6]
c. 23 Dec 1722
5
Martha Gilbert
[1.1.2.4.4]
b. Abt 1688
5
Benjamin Gilbert
[1.1.2.4.5]
b. 1 Feb 1691 d. 24 Jun 1760
5
Joseph Gilbert
[1.1.2.4.6]
b. 1 Feb 1691 d. Mar 1763
5
Noah Gilbert
[1.1.2.4.7]
b. 21 Nov 1703 d. 22 Nov 1768
3
Lydia Black
[1.1.3]
b. 25 Dec 1636
3
Lydia Black
[1.1.4]
b. 3 Jun 1638 d. Bef 1748
3
John Black, Jr
[1.1.5]
b. 1642 d. 18 Aug 1700
2
Patrick Black
[1.2]
b. 28 Sep 1692