Home Page
|
What's New
|
Photos
|
Histories
|
Headstones
|
Reports
|
Surnames
Search
First Name:
Last Name:
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Suomalainen
Svenska
Agnes Skeen
Abt 1537 - 1693 (156 years)
Submit Photo / Document
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Submit Photo / Doc
Worksheet
Family
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Agnes Skeen
[1]
b. Abt 1537 d. 1693
John Black
b. Abt 1540 d. 1591
2
Alexander Black
[1.1]
b. Abt 1559
2
Agnes Black
[1.2]
b. Abt 1564
2
John Black
[1.3]
b. Abt 1565
Elizabeth Locart
b. 1570 d. 1641
3
John Black
[1.3.1]
b. Abt 1613 d. 1 Mar 1675
Susanna Freeman
b. Abt 1610 d. Aft 1645
4
Persis Black
[1.3.1.1]
b. Abt 1627 d. 20 Jul 1677
William Follett
b. Abt 1625
5
Susanna Follett
[1.3.1.1.1]
b. 1 Jun 1662
Joseph Sibley
b. 1655 d. 25 Apr 1711
6
Joseph Sibley
[1.3.1.1.1.1]
b. 9 Nov 1685 d. 1754
Elizabeth Boutwell
b. 2 Mar 1683 d. Bef 1734
7
Joseph Sibley
[1.3.1.1.1.1.1]
b. 6 Mar 1709 d. 22 Aug 1777
7
John Sibley
[1.3.1.1.1.1.2]
b. 2 Aug 1711 d. 27 Nov 1778
7
James Sibley
[1.3.1.1.1.1.3]
b. 7 May 1714
7
Elizabeth Sibley
[1.3.1.1.1.1.4]
b. Abt 1716
7
Jonathan Sibley
[1.3.1.1.1.1.5]
b. 11 Sep 1718 d. 30 Mar 1787
7
Hannah Sibley
[1.3.1.1.1.1.6]
b. 27 Jun 1721
7
Susanna Sibley
[1.3.1.1.1.1.7]
b. 24 Aug 1723
7
Mary Sibley
[1.3.1.1.1.1.8]
b. 23 Sep 1725
6
John Sibley
[1.3.1.1.1.2]
b. 18 Sep 1687 d. 13 May 1741
Zerviah Gould
b. 20 Apr 1694 d. Bef 1741
7
Ebenezer Sibley
[1.3.1.1.1.2.1]
b. 28 Feb 1717 d. 4 Mar 1790
Abigail Cummings
b. 3 May 1716 d. 27 Sep 1783
8
Stephen Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.1]
b. 12 Jul 1741 d. 25 Aug 1828
Thankful Taft
b. 25 May 1745 d. 26 Oct 1837
9
Joel Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.1.1]
b. 25 Apr 1766 d. 10 Apr 1839
Lois Louise Woods
b. 24 Jun 1767 d. 21 Nov 1832
10
Amory Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.1.1.1]
b. 20 Jun 1792 d. 22 Jun 1849
Caroline Bosworth
b. Abt 1796 d. 13 Jan 1858
11
Martha Elmira Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.1.1.1.1]
b. 16 Oct 1839 d. 1 Oct 1920
Harriss de Antignac
b. 7 Oct 1837 d. 22 Jan 1909
12
Caroline de Antignac
[1.3.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1]
b. 9 Aug 1857 d. 11 Dec 1934 [
=>
]
10
Josiah Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.1.1.2]
b. 1 Apr 1808 d. 7 Dec 1888
Sarah Ann Sophia Crapon
b. 24 Oct 1809 d. 17 May 1858
11
Samuel Hale Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.1.1.2.1]
b. 9 Sep 1835 d. 1883
Sarah Virginia Hart
b. 22 Oct 1846 d. 3 Jun 1917
12
Josiah Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.1.1.2.1.1]
b. 1866 d. 1879
12
Grace Pendleton Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.1.1.2.1.2]
b. 1868 d. 1870
12
Jennie Hart Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.1.1.2.1.3]
b. 28 Dec 1869
12
Kate Collier Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.1.1.2.1.4]
b. 1872 d. 1921
12
Samuel Hale Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.1.1.2.1.5]
b. 12 Jul 1873 d. 13 Oct 1958 [
=>
]
12
James Hart Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.1.1.2.1.6]
b. 1875
11
William Crapon Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.1.1.2.2]
b. 3 May 1832 d. 17 Apr 1902
Jane Elizabeth Thomas
b. 13 Feb 1838 d. 21 Apr 1930
12
Anne Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.1.1.2.2.1]
b. 11 Mar 1862 d. Jun 1863
12
Josiah Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.1.1.2.2.2]
b. 19 Jan 1864 d. 11 Aug 1866
12
Grigsby Thomas Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.1.1.2.2.3]
b. 21 Dec 1865 d. 1 Aug 1954 [
=>
]
12
Barney Dunbar Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.1.1.2.2.4]
b. 18 Oct 1870 d. 5 Sep 1946 [
=>
]
11
Henry Josiah Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.1.1.2.3]
b. 19 Nov 1833 d. 25 Jul 1864
11
Sophia Matilda Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.1.1.2.4]
b. 16 Oct 1837 d. 29 Oct 1897
+
Charles E Smedes
11
George Royal Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.1.1.2.5]
b. 19 Jul 1839 d. 15 Jul 1895
Emma Susan Hansel Tucker
b. 20 May 1845 d. 1911
12
Alice Reese Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.1.1.2.5.1]
b. 18 Feb 1863 [
=>
]
12
Mary Lois Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.1.1.2.5.2]
b. Feb 1870
12
Annabelle Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.1.1.2.5.3]
b. Sep 1882
12
George Royal Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.1.1.2.5.4]
b. 17 Jun 1884
11
Fannie Maria Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.1.1.2.6]
b. 13 Oct 1841 d. 20 Dec 1842
11
Mary Lois Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.1.1.2.7]
b. 3 Sep 1843 d. 23 Feb 1864
11
Alice Marie Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.1.1.2.8]
b. 9 Feb 1846 d. 13 Jul 1907
+
William T Williams
11
Robert Pendelton Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.1.1.2.9]
b. Abt 1847
Susan Wheless Bolling
b. 19 Jan 1851
12
Bolling Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.1.1.2.9.1]
b. 20 Aug 1873
12
Frances Wheless Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.1.1.2.9.2]
b. 2 Jan 1875
12
Josiah Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.1.1.2.9.3]
b. 12 May 1877 [
=>
]
12
George R Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.1.1.2.9.4]
b. 8 Feb 1879
12
Robert Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.1.1.2.9.5]
b. 28 Mar 1881
12
Herbert Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.1.1.2.9.6]
b. 13 Oct 1885 d. Aug 1904
11
Caroline Crapon Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.1.1.2.10]
b. 21 Feb 1850 d. 16 Nov 1858
11
Amory Walter Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.1.1.2.11]
b. 19 Jun 1852 d. 28 Jul 1899
11
Josiah Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.1.1.2.12]
b. 1866 d. 1879
Emaline Eve
b. 1839
11
John Adam Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.1.1.2.13]
b. 1 Sep 1861 d. 26 Mar 1934
+
Sarah Louise Chandler
11
James Longstreet Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.1.1.2.14]
b. 4 Aug 1863 d. 10 Sep 1945
Martha Erwin
b. 1862 d. 22 Dec 1930
12
Martha Erwin Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.1.1.2.14.1]
b. 13 Feb 1886 d. 10 Aug 1975 [
=>
]
12
John Adams Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.1.1.2.14.2]
b. 4 Jan 1888 d. 25 Oct 1986
12
Ulysses Erwin Maner Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.1.1.2.14.3]
b. 9 Apr 1890 d. 31 Jul 1979
12
James Longstreet Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.1.1.2.14.4]
b. 29 Aug 1891 d. 24 May 1980
12
Josephine King Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.1.1.2.14.5]
b. 13 May 1893 d. 5 May 1980
12
Mary Eve Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.1.1.2.14.6]
b. 28 Nov 1895 d. 14 Dec 1918
12
Josiah Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.1.1.2.14.7]
b. 16 Sep 1898 d. 28 Dec 1965
12
William Augustus Longstreet Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.1.1.2.14.8]
b. 12 Feb 1900 d. 1 Dec 1994
12
Marion Erwin Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.1.1.2.14.9]
b. 12 Jan 1902 d. Jun 1985
12
Alan Bowen Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.1.1.2.14.10]
b. 22 Sep 1903 d. 13 Aug 1990
11
Mary Bones Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.1.1.2.15]
b. 29 Mar 1865 d. 22 Jun 1954
11
Emma Josephine Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.1.1.2.16]
b. 23 Feb 1867 d. 25 Oct 1957
Butler King Couper
b. Abt 1851 d. 20 Oct 1913
12
Constance Maxwell Couper
[1.3.1.1.1.2.1.1.1.2.16.1]
b. 1897 d. 1985
12
Butler King Couper
[1.3.1.1.1.2.1.1.1.2.16.2]
b. 1906 d. 1957
9
Lydia Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.1.2]
b. 2 Apr 1769 d. 27 Nov 1822
Henry Staples Benson
b. 8 Aug 1770 d. 29 Jul 1821
10
Abigail Benson
[1.3.1.1.1.2.1.1.2.1]
b. 31 Mar 1795 d. 10 Nov 1821
Asa Legg
b. 7 May 1792 d. 15 Nov 1836
11
Charlotte Legg
[1.3.1.1.1.2.1.1.2.1.1]
b. 2 May 1818 d. 30 Oct 1900
George Perrier Stawitts
b. 3 Jul 1820 d. 1897
12
Jacob Stawitts
[1.3.1.1.1.2.1.1.2.1.1.1]
b. Abt 1844
12
Cornelius Stanton Stawitts
[1.3.1.1.1.2.1.1.2.1.1.2]
b. 17 Feb 1846 d. 2 May 1914 [
=>
]
12
Herbert Stawitts
[1.3.1.1.1.2.1.1.2.1.1.3]
b. Abt 1848 d. Abt 1852
12
Emma Stawitts
[1.3.1.1.1.2.1.1.2.1.1.4]
b. Abt 1850
11
Lyman Legg
[1.3.1.1.1.2.1.1.2.1.2]
b. 3 Sep 1822 d. 1 Sep 1904
Hannah Thayer
b. 11 Feb 1820
12
Enoch J Legg
[1.3.1.1.1.2.1.1.2.1.2.1]
b. 25 Sep 1846
12
Enda Isadore Legg
[1.3.1.1.1.2.1.1.2.1.2.2]
b. 25 Sep 1846 d. 1 Sep 1914
12
Sarah Thayer Legg
[1.3.1.1.1.2.1.1.2.1.2.3]
b. 20 Oct 1850
10
Harriet Benson
[1.3.1.1.1.2.1.1.2.2]
b. 14 Sep 1796 d. 22 Aug 1852
10
Mellen Benson
[1.3.1.1.1.2.1.1.2.3]
b. 14 Jan 1798
Eliza W Farnum
b. 25 Sep 1802 d. 14 Sep 1839
11
Henry Staples Benson
[1.3.1.1.1.2.1.1.2.3.1]
b. 17 May 1829
11
Almira Farnum Benson
[1.3.1.1.1.2.1.1.2.3.2]
b. 6 Aug 1830 d. 25 Dec 1835
11
James Haskins Benson
[1.3.1.1.1.2.1.1.2.3.3]
b. 16 Oct 1833
11
George Everett Benson
[1.3.1.1.1.2.1.1.2.3.4]
b. 14 Aug 1837
+
Mary Windsor Peck
b. 21 May 1798
10
Hannah Adaline Benson
[1.3.1.1.1.2.1.1.2.4]
b. 12 Aug 1802 d. 19 Jun 1822
10
Rufus Benson
[1.3.1.1.1.2.1.1.2.5]
b. 24 Jan 1804 d. 23 Aug 1805
10
Chloe Ann Benson
[1.3.1.1.1.2.1.1.2.6]
b. 23 Aug 1806
+
Dan Hill
b. 29 Nov 1796
10
Susan Augusta Benson
[1.3.1.1.1.2.1.1.2.7]
b. 9 Oct 1809 d. 25 Jul 1831
Preserved Smith Thayer
b. 9 May 1808
11
Susan Benson Thayer
[1.3.1.1.1.2.1.1.2.7.1]
b. 28 Jun 1831 d. 14 Aug 1909
+
Daniel Wheelock Aldrich
b. 28 Aug 1822 d. 23 May 1891
10
Rufus Aldrich Benson
[1.3.1.1.1.2.1.1.2.8]
b. 9 Oct 1809
+
Sarah E Buell
10
Stephen Sibley Benson
[1.3.1.1.1.2.1.1.2.9]
b. 9 Jan 1810 d. 20 Nov 1869
Elizabeth Richardson Scott
b. 8 Jan 1835 d. 20 Feb 1911
11
Jessie Harriet Benson
[1.3.1.1.1.2.1.1.2.9.1]
b. 7 Jun 1860
+
John Robert Forbes Love
b. 22 Jun 1856
11
Fred Mellen Benson
[1.3.1.1.1.2.1.1.2.9.2]
b. 10 Nov 1862 d. 9 May 1864
11
Susie Adeline Benson
[1.3.1.1.1.2.1.1.2.9.3]
b. 6 Aug 1865
8
Ebenezer Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.2]
b. 9 Oct 1745
Mary Chase
b. 15 Mar 1741 d. 1784
9
Sarah Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.2.1]
b. 19 Dec 1772
9
Lucy Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.2.2]
b. 2 Mar 1775
+
Forbes Bond
b. Abt 1773
9
Eunice Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.2.3]
b. 1 Mar 1777
9
Elias Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.2.4]
b. 8 Aug 1779 d. 1856
Ruth Chase
b. 31 Jan 1780 d. Abt 1858
10
Alonzo Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.2.4.1]
b. 14 Jul 1810 d. 16 Mar 1896
Mary Heath
b. 10 Sep 1813 d. 1836
11
Son Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.2.4.1.1]
b. 20 Oct 1836 d. 5 Dec 1836
Sarah Ann Heath
b. 10 Apr 1812 d. 1873
11
Daughter Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.2.4.1.2]
b. 1838 d. 7 Jul 1838
11
Mary Jane Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.2.4.1.3]
b. 17 Nov 1840 d. 15 Feb 1922
James Pratt
b. May 1835
12
Melville S Pratt
[1.3.1.1.1.2.1.2.4.1.3.1]
b. 5 May 1868 d. 7 Mar 1947
12
Maude Ethlyn Pratt
[1.3.1.1.1.2.1.2.4.1.3.2]
b. 17 Jun 1871 d. 6 Nov 1897
12
Judson Edmond Pratt
[1.3.1.1.1.2.1.2.4.1.3.3]
b. 12 Mar 1885 d. Apr 1972
12
Emma G Pratt
[1.3.1.1.1.2.1.2.4.1.3.4]
b. 23 Jun 1888
11
Harriet A Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.2.4.1.4]
b. 25 Nov 1842 d. 6 Jul 1886
James Bryant Drew
b. 11 Nov 1838 d. 8 Apr 1903
12
Ray Sibley Drew
[1.3.1.1.1.2.1.2.4.1.4.1]
b. 17 Apr 1870 d. 14 Feb 1949 [
=>
]
11
Watson A Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.2.4.1.5]
b. 1844 d. 24 Apr 1924
Margaret H. Hubbell
b. Jul 1849
12
Guy Hubbell Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.2.4.1.5.1]
b. 8 Dec 1872 d. 19 Mar 1936
12
Caroline A Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.2.4.1.5.2]
b. 3 Nov 1874 d. Mar 1976
12
May Viola Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.2.4.1.5.3]
b. 30 Apr 1876
12
Cora I Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.2.4.1.5.4]
b. 11 Jul 1880
11
Judson L Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.2.4.1.6]
b. Oct 1846
Lucia Emma Banks
b. Jun 1851
12
Gertrude R Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.2.4.1.6.1]
b. 6 Nov 1876
+
Adeline Colby
b. 10 Jun 1818 d. 18 Mar 1896
9
Ebenezer Sibley, Jr
[1.3.1.1.1.2.1.2.5]
b. 18 Jan 1782 d. 15 Mar 1827
Polly B Whipple
b. 16 Jun 1791
10
Lorinda Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.2.5.1]
b. 6 Jul 1810
+
Charles Arnold
10
Maria Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.2.5.2]
b. 23 Jul 1812
Whitcomb Gray
b. Abt 1804 d. 10 Jan 1888
11
Delia Maria Gray
[1.3.1.1.1.2.1.2.5.2.1]
b. 1834
+
James Carpenter
b. 1832
11
Mary Ann Grey
[1.3.1.1.1.2.1.2.5.2.2]
c. 20 Mar 1836
+
Moses H. Rumery
b. 1831
10
Polly Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.2.5.3]
b. 11 Sep 1814
10
Mary Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.2.5.4]
b. 8 Mar 1817 d. 17 Jun 1903
Benjamin Cragin
b. 6 Mar 1814 d. 20 Jan 1896
11
Mary Emma Cragin
[1.3.1.1.1.2.1.2.5.4.1]
b. 12 Dec 1839 d. 25 Aug 1924
Joshua Vose
b. 6 Jul 1838 d. 10 Apr 1918
12
Hattie M Vose
[1.3.1.1.1.2.1.2.5.4.1.1]
b. 20 Mar 1869 d. Aft 1930 [
=>
]
12
Mary Louise Vose
[1.3.1.1.1.2.1.2.5.4.1.2]
b. 24 Sep 1875
11
Maria A Cragin
[1.3.1.1.1.2.1.2.5.4.2]
b. 27 Dec 1844
10
Loren Elba Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.2.5.5]
b. 3 May 1821
9
Zadock Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.2.6]
b. 12 Oct 1785
9
Mary Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.2.7]
b. 1 Feb 1789 d. 24 Apr 1844
+
Amos Peirce
b. Abt 1786 d. 22 Dec 1848
8
Abigail Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.3]
b. 22 Jan 1747
8
Peter Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.4]
b. 16 Sep 1749
8
Mary Sibley
[1.3.1.1.1.2.1.5]
b. 20 Jan 1751
7
Stephen Sibley
[1.3.1.1.1.2.2]
b. 1 Oct 1720
Mrs Sibley
b. Abt 1725
8
Elias Sibley
[1.3.1.1.1.2.2.1]
b. Abt 1745
7
Bethiah Sibley
[1.3.1.1.1.2.3]
b. 2 Oct 1724 d. 1 Jul 1756
Samuel Trask
b. 17 Dec 1721 d. 7 Mar 1790
8
John Trask
[1.3.1.1.1.2.3.1]
b. 29 Sep 1744
8
Hannah Trask
[1.3.1.1.1.2.3.2]
b. 10 Nov 1746
8
Sarah Trask
[1.3.1.1.1.2.3.3]
b. 10 Sep 1753 d. 22 Aug 1830
Major Simon Tenney
b. 13 Sep 1746 d. 14 Aug 1838
9
Major Daniel Tenney
[1.3.1.1.1.2.3.3.1]
b. 23 Nov 1773
Betsey Waters
b. 12 Jul 1776 d. 16 Aug 1851
10
Sarah Tenney
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.1]
b. 6 Oct 1797 d. 13 Apr 1880
Edmond John Mills
b. 17 Aug 1791 d. 11 Sep 1889
11
Wiliam Edmund Mills
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.1.1]
b. 2 Nov 1825 d. 18 Dec 1914
Electa Jane Dusenbury
b. 18 Apr 1828 d. 6 Oct 1908
12
Frank Henry Mills
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.1.1.1]
b. 17 Aug 1853 d. 1903 [
=>
]
12
Frances Harriet Mills
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.1.1.2]
b. 17 Aug 1853 d. 1903
12
William Edmond Mills
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.1.1.3]
b. 4 Jul 1855 [
=>
]
11
Nancy Tenney Mills
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.1.2]
b. 15 Mar 1828 d. 12 Jun 1880
Leander C Taylor
b. 1826 d. 12 Jan 1902
12
Elizabeth Jane Taylor
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.1.2.1]
b. Abt 1857 d. 23 Nov 1885
11
Samuel John Mills
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.1.3]
b. 17 Nov 1830 d. 23 Jan 1838
11
Son Mills
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.1.4]
b. 1 Mar 1835 d. 31 Mar 1835
11
Franklin Lewis Mills
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.1.5]
b. 24 Oct 1836 d. 14 Feb 1918
+
Susannah E Kraft
b. Sep 1846 d. 30 Mar 1876
Caroline Morse
b. 23 Apr 1856 d. 1900
12
Sarah Jane Mills
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.1.5.1]
b. 4 Jul 1881 d. 18 Jan 1889
12
Grace Evelyn Mills
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.1.5.2]
b. 7 Nov 1891 d. Aft 1900
11
Sarah Maria Mills
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.1.6]
b. 18 Aug 1841
10
Sally Tenney
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.2]
b. 6 Oct 1797
10
Simon Tenney
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.3]
b. 3 Dec 1799 d. 11 Jun 1856
Nancy Putnam
b. 17 Feb 1800
11
David Tenney
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.3.1]
b. Abt 1830
11
Daniel Tenney
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.3.2]
b. 29 Feb 1832 d. 6 Dec 1844
11
George Tenney
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.3.3]
b. 30 Jan 1837 d. 29 Oct 1839
10
John Waters Tenney
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.4]
b. 25 Jul 1802 d. 29 Apr 1849
Eliza Tileston Fisher
b. 13 May 1803 d. 21 Aug 1847
11
Edward Waters Tenney
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.4.1]
b. Aug 1830
Lucene Ida Haines
b. 8 Oct 1859
12
Lena L Tenny
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.4.1.1]
b. Feb 1879 d. 1942
12
Charles William Tenney
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.4.1.2]
b. 3 Jan 1882
10
Linus Tenney
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.5]
b. 5 Dec 1804
Sally Elwell
b. 2 Dec 1806
11
Charles Linus Tenney
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.5.1]
b. 12 Jan 1829
Catherine Fisk Robbins
b. 1 Nov 1837 d. 8 Feb 1902
12
Edith Frances Tenney
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.5.1.1]
b. 4 Jul 1860 d. 28 Jan 1872
12
Eleanore Amelia Tenney
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.5.1.2]
b. 15 Aug 1862 d. 15 Jan 1865
12
Eva Nena Tenney
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.5.1.3]
b. 8 Apr 1867 d. 12 Nov 1943
12
Lucius E Tenney
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.5.1.4]
b. 22 Jul 1874 d. 1 Jul 1905
12
Rhoda Hannah Tenney
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.5.1.5]
b. 13 Sep 1876
11
George Franklin Tenney
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.5.2]
b. 7 Sep 1831 d. 24 Nov 1831
11
James Henry Tenney
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.5.3]
b. 10 Jun 1838
Arabella Adeline Prichard
b. 11 Oct 1842 d. 22 Mar 1907
12
James Edgar Tenney
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.5.3.1]
b. 2 Apr 1863 d. 6 Jan 1890
12
Florence Mabelle Tenney
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.5.3.2]
b. 10 May 1869 d. 15 Mar 1871
12
Grace Elwell Tenney
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.5.3.3]
b. 10 May 1873
12
Blanche Mack Tenney
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.5.3.4]
b. 27 Sep 1876
12
Ethel Prichard Tenney
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.5.3.5]
b. 18 Dec 1879 d. 6 Jan 1884
10
Nancy Tenney
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.6]
b. 21 Jan 1808 d. 29 May 1822
10
Danial Austin Tenney
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.7]
b. 29 Aug 1811 d. 7 Feb 1871
Marietta Margaret Marcy
b. 11 Jun 1811
11
Daniel Austin Tenney
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.7.1]
b. 15 Oct 1835
Maria Louisa Newton
b. 20 Jul 1843
12
Mary Effie Tenney
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.7.1.1]
b. 12 Jul 1868
12
Ada Mabel Tenney
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.7.1.2]
b. 25 Jan 1870
11
Joseph Starks Tenney
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.7.2]
b. 24 Feb 1838
Emily M Paine
b. Abt 1842
12
George Arthur Tenney
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.7.2.1]
b. 8 Oct 1858
11
George Laban Tenney
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.7.3]
b. 25 Jul 1840
11
Frederick Prescott Tenney
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.7.4]
b. 6 Jul 1845
11
Frank Herbert Tenney
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.7.5]
b. 16 Jan 1849
Ellen Arnold Searles
b. 6 Mar 1847 d. 7 Oct 1904
12
Fannie Augusta Tenney
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.7.5.1]
b. 7 Aug 1878
10
Benjamin Franklin Tenney
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.8]
b. 28 Oct 1813 d. 26 Oct 1900
Frances Bridges Veagie
b. 7 Mar 1819 d. 24 Oct 1858
11
Joseph Franklin Tenney
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.8.1]
b. 12 Nov 1838 d. 1878
Mary Bowman Viles
b. 17 Feb 1831
11
Frank Tenney
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.8.2]
b. 4 Feb 1861
11
Arthur Tenney
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.8.3]
b. 1 Jun 1863 d. 16 Jun 1866
11
Maud Tenney
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.8.4]
b. 13 May 1875 d. 30 Jun 1896
Frank Foster Sherburne
12
Ruth Sherburne
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.8.4.1]
b. 18 Jun 1893
12
Elizabeth Sherburne
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.8.4.2]
b. 25 Jul 1894
12
Tenny Sherburne
[1.3.1.1.1.2.3.3.1.8.4.3]
b. 24 Jun 1899
8
Samuel Trask, Jr
[1.3.1.1.1.2.3.4]
b. 26 Aug 1749
Ruth Tenney
b. 16 Mar 1753 d. 27 Apr 1789
9
Samuel Trask, III
[1.3.1.1.1.2.3.4.1]
b. 10 Dec 1773
9
Simon Trask
[1.3.1.1.1.2.3.4.2]
b. 13 Jan 1775
9
Hannah Trask
[1.3.1.1.1.2.3.4.3]
b. 4 Feb 1777
9
Stephen Trask
[1.3.1.1.1.2.3.4.4]
b. 18 Feb 1779
9
Salley Trask
[1.3.1.1.1.2.3.4.5]
b. 17 Jan 1784 d. 5 Feb 1819
Elijah Holman
10
Jonathan Holman
[1.3.1.1.1.2.3.4.5.1]
b. 21 Jun 1813 d. 24 Oct 1816
10
Sarah Trask Holman
[1.3.1.1.1.2.3.4.5.2]
b. 16 May 1816 d. 8 May 1847
Sherman Hale
b. Abt 1812
11
Anna Hale
[1.3.1.1.1.2.3.4.5.2.1]
b. Abt 1838
11
Ann Hale
[1.3.1.1.1.2.3.4.5.2.2]
b. 1840
11
Emily Hale
[1.3.1.1.1.2.3.4.5.2.3]
b. Jul 1841 d. 2 Nov 1906
11
Anna H Hale
[1.3.1.1.1.2.3.4.5.2.4]
b. Feb 1843 d. 5 Jan 1929
11
Sarah Frank Hale
[1.3.1.1.1.2.3.4.5.2.5]
b. 16 Dec 1844 d. 30 Oct 1933
11
Charles T H Hale
[1.3.1.1.1.2.3.4.5.2.6]
b. 1846
10
Son Holman
[1.3.1.1.1.2.3.4.5.3]
b. Abt 1819 d. 23 Feb 1826
Allice Perry
b. Abt 1759
9
Talmon Trask
[1.3.1.1.1.2.3.4.6]
c. 6 Oct 1799
9
Danforth Trask
[1.3.1.1.1.2.3.4.7]
c. 27 Nov 1801
9
Dexter Trask
[1.3.1.1.1.2.3.4.8]
c. 11 Aug 1807
9
Edwin Trask
[1.3.1.1.1.2.3.4.9]
c. 29 Sep 1809
9
Angelina Trask
[1.3.1.1.1.2.3.4.10]
c. 26 Oct 1811
8
Anne Trask
[1.3.1.1.1.2.3.5]
b. 9 Oct 1757
7
Timothy Sibley
[1.3.1.1.1.2.4]
b. 2 Nov 1727 d. 6 Dec 1818
Ann Waite
b. 14 Oct 1733 d. 12 Mar 1791
8
John Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.1]
b. 19 May 1757 d. 8 Apr 1837
Betsey Hopkins
b. Abt 1754 d. 1790
9
George Champlin Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.1.1]
b. 1 Apr 1782 d. 31 Jan 1863
+
Mary Smith Easton
b. 24 Jan 1800 d. 20 Jun 1878
8
Timothy Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2]
b. 19 Jun 1754 d. 26 Aug 1829
Mary
b. Abt 1756
9
Timothy Willard Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.1]
b. 11 Sep 1779 d. 11 Mar 1820
Elizabeth Comins
d. 2 Mar 1820
10
William C Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.1.1]
b. 20 Jun 1812
10
Sarah Elizabeth Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.1.2]
b. 2 Jan 1814
10
Mary Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.1.3]
b. 26 Sep 1815
10
Amanda M Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.1.4]
b. 25 Jun 1817
10
Nancy W Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.1.5]
b. 10 Jul 1819
Francis S Putney
b. 20 Oct 1818
11
William Frank Putney
[1.3.1.1.1.2.4.2.1.5.1]
b. 23 Sep 1844 d. 11 Feb 1847
11
Frank Edward Putney
[1.3.1.1.1.2.4.2.1.5.2]
b. 12 Apr 1847 d. Dec 1849
11
William Sibley Putney
[1.3.1.1.1.2.4.2.1.5.3]
b. 24 Mar 1849 d. 16 Jan 1933
+
Lavina Jane Call
b. 14 Aug 1852
11
Clara A Putney
[1.3.1.1.1.2.4.2.1.5.4]
b. 28 Sep 1850
11
Mary Ann Putney
[1.3.1.1.1.2.4.2.1.5.5]
b. 25 Dec 1852 d. 13 May 1881
Sheldon M Scribner
b. 22 Sep 1848
12
Howard S Scribner
[1.3.1.1.1.2.4.2.1.5.5.1]
b. 29 Jul 1876
12
Harlan W Scribner
[1.3.1.1.1.2.4.2.1.5.5.2]
b. 6 Mar 1878
12
Orrin F Scribner
[1.3.1.1.1.2.4.2.1.5.5.3]
b. 23 Sep 1879 d. 10 Jul 1880
11
Josephine E Putney
[1.3.1.1.1.2.4.2.1.5.6]
b. 16 Dec 1854 d. 26 Dec 1857
11
Orrin F Putney
[1.3.1.1.1.2.4.2.1.5.7]
b. 20 Dec 1856 d. 20 Mar 1881
11
Luther C Putney
[1.3.1.1.1.2.4.2.1.5.8]
b. 26 Jul 1859 d. 1920
Anna P Wadleigh
b. 11 Oct 1868 d. 6 Aug 1894
12
Winnifred Maude Putney
[1.3.1.1.1.2.4.2.1.5.8.1]
b. 8 Oct 1893
11
Fred Willard Putney
[1.3.1.1.1.2.4.2.1.5.9]
b. 21 Jan 1866 d. 26 Dec 1930
Evelyn Angusta Breed
b. 26 Mar 1869 d. 19 May 1932
12
Luther Roy Putney
[1.3.1.1.1.2.4.2.1.5.9.1]
b. 10 Jun 1890
10
Almira S Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.1.6]
9
Mary Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.2]
b. 5 Dec 1780
+
Amariah Scarboro
9
Anne Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.3]
b. 15 Jan 1782
9
Cyrus Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.4]
b. 6 Jan 1784
Eliza Ann Humphries
b. 9 Sep 1809 d. 4 Oct 1884
10
Artemas Origin Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.4.1]
b. 9 Mar 1829
Eloise Soria
11
Robert A Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.4.1.1]
b. 25 Nov 1855 d. 18 Jul 1902
11
Artemise Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.4.1.2]
b. 1861
11
Eugene Walter Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.4.1.3]
b. 25 Mar 1865 d. 23 Apr 1945
Florence Cleora D'Olive
12
Florence Eloise Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.4.1.3.1]
b. 9 Aug 1890 d. 14 Jun 1983
12
Eugene Soria Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.4.1.3.2]
b. 9 Jul 1892 d. 9 Sep 1960
12
Cyrus Rufus Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.4.1.3.3]
b. 18 Oct 1896 d. 11 Sep 1939
12
William Fonde Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.4.1.3.4]
b. 1904 d. 19 Nov 1937 [
=>
]
12
Vernon Lynnwood Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.4.1.3.5]
b. 23 Sep 1907 d. 25 Jul 1974
11
Cyrus Artemas Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.4.1.4]
b. 25 Aug 1866 d. 25 Aug 1949
Elizabeth O'Conner
b. 2 Apr 1883 d. 19 Nov 1970
12
Cyrus Artemus Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.4.1.4.1]
b. 1904
11
Hattie S Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.4.1.5]
b. 1870
11
Annie Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.4.1.6]
b. 1872
11
William Soria Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.4.1.7]
b. 12 Sep 1874 d. 12 Feb 1968
10
Salome Jane Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.4.2]
b. 19 Dec 1829 d. 12 Apr 1835
10
Artemesia Ann Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.4.3]
b. 31 Jul 1830 d. 1 Sep 1903
Robert Brown Searing
b. 15 May 1829 d. 2 May 1890
11
Robert Brian Searing
[1.3.1.1.1.2.4.2.4.3.1]
b. 1859 d. 1878
11
Harry Pond Searing
[1.3.1.1.1.2.4.2.4.3.2]
b. 1863 d. 20 Dec 1873
11
Cyrus Sibley Searing
[1.3.1.1.1.2.4.2.4.3.3]
11
Florence Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.4.3.4]
11
Theodore Searing
[1.3.1.1.1.2.4.2.4.3.5]
10
Willard Franklin Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.4.4]
b. 18 Apr 1835
10
Cyrus Blue Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.4.5]
b. 18 Apr 1837
10
Helena Jane Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.4.6]
b. 27 May 1839
10
Henrietta Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.4.7]
b. 1842 d. 6 Feb 1892
10
Walter Howard Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.4.8]
10
Augustus Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.4.9]
9
Artemas Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.5]
b. 21 Apr 1786
9
Salome Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.6]
b. 13 Apr 1788 d. Aft 1880
Elijah Jewett
b. 8 Feb 1782 d. 1879
10
John F Jewett
[1.3.1.1.1.2.4.2.6.1]
b. 1817
+
Elizabeth How
b. Abt 1819
10
Origin Sibley Jewett
[1.3.1.1.1.2.4.2.6.2]
b. 20 Apr 1820 d. 19 Sep 1863
Clara Lee James
b. 25 Oct 1832 d. 1912
11
Origin Sibley Jewett
[1.3.1.1.1.2.4.2.6.2.1]
b. 1860 d. 1908
Virginia Flinn
b. 26 Jul 1871 d. 17 Apr 1942
12
Son Jewett
[1.3.1.1.1.2.4.2.6.2.1.1]
b. 12 Dec 1905 d. 12 Dec 1905
10
Mary Elizabeth Jewett
[1.3.1.1.1.2.4.2.6.3]
b. Abt 1821 d. 1901
Armistead M Elgin
b. 1819
11
Isabella Elgin
[1.3.1.1.1.2.4.2.6.3.1]
b. 20 May 1857 d. 30 May 1924
Cornelius E Thames
b. 1859
12
Armistead Elgin Thames
[1.3.1.1.1.2.4.2.6.3.1.1]
b. Abt 1884 d. 22 Jan 1964
12
Cornelius E Thames, Jr
[1.3.1.1.1.2.4.2.6.3.1.2]
b. Abt 1886 d. Aft 1940
12
Eugene Thames
[1.3.1.1.1.2.4.2.6.3.1.3]
b. Abt 1889 d. 8 Jun 1942 [
=>
]
11
Willie A Elgin
[1.3.1.1.1.2.4.2.6.3.2]
b. 18 Jan 1860 d. 12 Apr 1875
11
Clara J Elgin
[1.3.1.1.1.2.4.2.6.3.3]
b. Abt 1863 d. 25 Apr 1959
+
John H Fitzpatrick
b. Abt 1860
11
Elizabeth May Elgin
[1.3.1.1.1.2.4.2.6.3.4]
b. 1867 d. 24 Jan 1936
+
Edward Gray Caufman
b. 17 Sep 1834 d. 5 Mar 1907
9
Benijamin Franklin Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.7]
b. 19 Jul 1790
9
Origen Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.8]
b. 1792 d. 1870
Elizabeth Barlow
b. 8 May 1815 d. 2 Jul 1875
10
Josephine Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.1]
b. 2 Jul 1835 d. 3 Mar 1873
George W Barnaby
d. 1859
11
Bessie Barnaby
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.1.1]
b. 14 Jan 1857
+
Martin Kent Northam
11
George Adam Barnaby
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.1.2]
b. 14 Jan 1857 d. 1897
William Motley Stevens
d. 1870
11
Lloyd Motley Stevens
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.1.3]
b. 13 Jan 1869 d. 13 Jun 1955
10
Salome Elizabeth Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.2]
b. 19 Aug 1837 d. 1 Nov 1893
Nathaniel Ragan King
b. 18 Jun 1831 d. 19 Nov 1863
11
Marietta King
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.2.1]
b. 8 Sep 1858
William M King
12
Harvey King
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.2.1.1]
b. 16 Jul 1891
11
Sibley Paul King
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.2.2]
b. 5 Jun 1860
11
Idyl King
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.2.3]
b. 23 Feb 1862
William Edwin Gorsby
12
Paul Clinton Gorsby
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.2.3.1]
11
Nathalie Ragan King
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.2.4]
b. 6 May 1863
Charles Friend Warriner
b. 28 Jan 1855
12
Olga G Warriner
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.2.4.1]
b. 14 Jan 1889
12
Nathalie Warriner
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.2.4.2]
b. 17 Jan 1890
12
Mabel Warriner
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.2.4.3]
b. 6 Mar 1891
12
Laura Salome Warriner
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.2.4.4]
b. 1893
10
Origen Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.3]
b. 6 Feb 1840
Harriet A Brainerd
b. 1 Feb 1845
11
James Brainard Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.3.1]
b. 15 May 1869
+
Adele Estelle Ward
11
Origen Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.3.2]
b. 30 Jun 1872
11
Orlean Emma Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.3.3]
b. 30 Jun 1872 d. 27 Oct 1872
11
Will Owen Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.3.4]
b. 1 May 1880 d. 13 Aug 1880
10
Laura Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.4]
b. 1842
William G McNeill
11
Mary Elizabeth McNeill
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.4.1]
b. 8 Mar 1865
Ludolph Chester
12
Alan Chester
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.4.1.1]
11
William Stoddard McNeill
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.4.2]
b. 6 Dec 1866 d. 14 Apr 1868
11
Laurence Harvey McNeill
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.4.3]
b. 10 Aug 1869
11
Fanny Ethel McNeill
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.4.4]
b. 21 May 1871
11
Daniel McNeill
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.4.5]
b. 22 Sep 1872
11
Lila Douglas McNeill
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.4.6]
b. 10 Apr 1877 d. 1954
10
Franklin Edward Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.5]
b. 1844
Ida K Sterne
11
Helen May Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.5.1]
b. 1879 d. 1880
11
Frank Eillott Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.5.2]
b. 1881 d. 1943
11
Ida Valerie Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.5.3]
b. 1883 d. 1979
11
Julian Dannis Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.5.4]
b. 1885 d. 1964
11
Rowland Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.5.5]
b. 1890 d. 1901
10
Helen Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.6]
b. 15 Dec 1846 d. 1940
Audubon Gullette
11
Laura Helen Gullette
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.6.1]
b. 30 Oct 1867
Samuel Barlow
b. Abt 1867
12
Nellie Barlow
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.6.1.1]
b. 1888
11
Elizabeth Gullette
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.6.2]
b. 1869
+
Albert Putnam
11
Eugenia Gullette
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.6.3]
b. 9 Mar 1874
+
Samuel Cad Wallader Dodge
10
Charles Sweet Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.7]
b. 25 Jan 1849
Edna G D'Olive
b. 1872
11
Edna Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.7.1]
b. Dec 1890 d. 1987
10
Eugene Wilson Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.8]
b. 16 Sep 1851 d. 4 Mar 1911
Minnie M Sterne
11
Edward Austin Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.8.1]
d. 1960
11
Elizabeth Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.8.2]
d. 1896
11
Laurence Sterne Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.8.3]
d. 1901
10
Guy Clarence Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.9]
b. 1855
Susie Witherspoon Shipman
b. 29 Apr 1858 d. 27 Mar 1934
11
Guy Clarence Shipley, Jr
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.9.1]
b. 28 Jan 1883 d. 21 Feb 1912
10
Julia Eve Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.10]
b. 16 Jan 1856
Edward L Barnes
b. 23 Jan 1850
11
Anderson Barnes
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.10.1]
b. 28 Oct 1877
+
Olga Warines
b. 1889
11
Origen Sibley Barnes
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.10.2]
b. 2 Sep 1879 d. 1884
11
Edward L Barnes
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.10.3]
+
Annie
11
Pendleton Barnes
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.10.4]
11
Sager Barnes
[1.3.1.1.1.2.4.2.8.10.5]
8
Joshua Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.3]
b. 16 Nov 1755 d. 29 Sep 1774
8
Stephen Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.4]
b. 19 May 1757 d. 2 Jun 1759
8
Stephen Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.5]
b. 10 Nov 1759 d. 21 Apr 1829
8
Ebenezer Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.6]
b. 7 Apr 1761 d. 10 Sep 1839
Lydia Beach
b. 15 May 1766 d. 6 Mar 1834
9
John Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.6.1]
b. 3 Jul 1791
Nancy Kellog
b. 12 Mar 1809 d. 13 Jun 1885
10
Huldah Ann Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.6.1.1]
b. 13 Dec 1839 d. 30 Aug 1874
Carlos C Martin
b. 28 Dec 1819 d. 23 Oct 1894
11
Carlos Sibley Martin
[1.3.1.1.1.2.4.6.1.1.1]
b. 22 Jul 1866 d. 19 Jun 1952
Sylvia Alice Hazard
b. 12 Apr 1869 d. 18 Oct 1938
12
Anna Caroline Martin
[1.3.1.1.1.2.4.6.1.1.1.1]
b. 16 Aug 1902 d. 22 Nov 1986
11
George Chapman Martin
[1.3.1.1.1.2.4.6.1.1.2]
b. 17 May 1868 d. 23 Jun 1921
+
Marrian Lane
b. 1871
10
Ebenezer Kellogg Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.6.1.2]
b. 21 Sep 1841 d. 29 Sep 1895
+
Ellen Welty
b. 21 Jul 1848 d. 8 Sep 1931
10
George Whitney Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.6.1.3]
b. 17 Jan 1843 d. 7 Jul 1911
Mary L Woodward
b. 21 Sep 1845 d. 1 Jan 1876
11
George Woodward Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.6.1.3.1]
b. 2 Apr 1869 d. 3 Nov 1941
Louella Irene Bright
b. 25 Aug 1858 d. 23 Apr 1926
12
Luella Marie Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.6.1.3.1.1]
b. 11 Oct 1895 d. 12 Apr 1984 [
=>
]
12
Frederick Woodward Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.6.1.3.1.2]
b. 26 Jan 1912 d. 29 Jul 1925
12
George Allen Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.6.1.3.1.3]
b. 14 Jan 1913 d. 23 Jul 1983 [
=>
]
12
Edwin Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.6.1.3.1.4]
b. 24 Jun 1919 d. 16 Dec 1935
Hedwig Fredrick
b. 11 Apr 1879
12
Frederick Woodward Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.6.1.3.1.5]
b. 26 Jan 1912 d. 29 Jul 1925
12
George Allen Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.6.1.3.1.6]
b. 14 Jan 1913 d. 23 Jul 1983 [
=>
]
12
Edwin Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.6.1.3.1.7]
b. 24 Jun 1919 d. 16 Dec 1935
11
John Whitney Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.6.1.3.2]
b. 19 Jan 1875
Reteena Jasmine Sanders
b. 26 Apr 1850 d. 2 Jun 1929
11
Anna May Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.6.1.3.3]
b. 28 Oct 1879 d. 4 Sep 1962
David Welty Divine
b. 9 Nov 1867 d. 11 Jul 1935
12
Elizabeth Sibley Divine
[1.3.1.1.1.2.4.6.1.3.3.1]
b. 8 Sep 1909 d. 30 May 1992
12
William Welty Divine
[1.3.1.1.1.2.4.6.1.3.3.2]
b. 18 May 1912 d. 10 Mar 1984
12
George Whitney Divine
[1.3.1.1.1.2.4.6.1.3.3.3]
b. 30 Nov 1914 d. 27 Dec 1982
+
Victor S Yarros
b. 8 Apr 1865 d. 30 Oct 1956
11
Elizabeth Kellogg Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.6.1.3.4]
b. 29 Aug 1884 d. 6 Sep 1943
+
Edgar Allen Truby
b. 6 Dec 1872 d. 12 Mar 1921
11
John Whitney Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.6.1.3.5]
b. 17 Mar 1886 d. 29 Jul 1976
+
Marion Augusta Simmons
b. Abt 1886 d. 12 Dec 1978
10
John Nelson Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.6.1.4]
b. 10 Nov 1844 d. 4 Jan 1880
10
Benjamin Franklin Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.6.1.5]
b. 5 Aug 1846 d. 1907
Lucia Marion Hill
b. 27 Dec 1848
11
Delia M Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.6.1.5.1]
b. 1874 d. 1876
11
William H Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.6.1.5.2]
b. 1877 d. 1888
11
Arthur K Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.6.1.5.3]
b. 1882 d. 1888
11
Hiram W Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.6.1.5.4]
b. 1884 d. 1886
11
George H Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.6.1.5.5]
b. 1892 d. 1893
10
Hiram Beach Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.6.1.6]
b. 4 Mar 1849 d. 20 Sep 1876
+
Mary Ann Wheeler
b. 13 Apr 1851 d. 25 Jan 1926
9
Timothy Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.6.2]
b. 4 Feb 1803 d. 24 Sep 1880
8
Anna Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.7]
b. 15 Dec 1762 d. 17 Sep 1792
Samuel Hoyt
b. 24 Jan 1739 d. 22 Nov 1821
9
Lydia Hoyt
[1.3.1.1.1.2.4.7.1]
b. 9 Apr 1779 d. Aft 1850
Jonathan Bean
b. 26 Feb 1776 d. 9 Nov 1844
10
Sopia Bean
[1.3.1.1.1.2.4.7.1.1]
b. 16 Jun 1799
10
Fanny Bean
[1.3.1.1.1.2.4.7.1.2]
b. 20 Jan 1801
10
Otis Bean
[1.3.1.1.1.2.4.7.1.3]
b. 26 Dec 1802
10
Asa Bean
[1.3.1.1.1.2.4.7.1.4]
b. 13 Mar 1805 d. 18 Apr 1856
Jane D Stone
b. 20 Jan 1820 d. 30 Jul 1896
11
Leenze Bean
[1.3.1.1.1.2.4.7.1.4.1]
b. 4 Sep 1840 d. 1 Mar 1841
11
Julia Ann Judson Bean
[1.3.1.1.1.2.4.7.1.4.2]
b. 15 Feb 1842 d. 7 Jul 1927
11
Adeniran Judson Bean
[1.3.1.1.1.2.4.7.1.4.3]
b. Abt 1843 d. 12 Jun 1888
+
Larzetta Anderson
b. 11 Dec 1849 d. 2 Feb 1875
+
Kate Kirkwood
11
Harriet Newell Bean
[1.3.1.1.1.2.4.7.1.4.4]
b. 21 Jun 1847 d. 25 Dec 1928
+
George W Simmons
11
William Gustin Bean
[1.3.1.1.1.2.4.7.1.4.5]
b. 8 Jan 1850 d. 5 Apr 1850
11
Fanny Jeanette Bean
[1.3.1.1.1.2.4.7.1.4.6]
b. 28 May 1852
Albion F Pearson
b. 1850 d. 1882
12
Nettie Alice Pearsons
[1.3.1.1.1.2.4.7.1.4.6.1]
b. 14 Feb 1871 d. 7 Jul 1951 [
=>
]
12
Lillian P Pearson
[1.3.1.1.1.2.4.7.1.4.6.2]
b. 10 Sep 1877
12
Albion N Pearson
[1.3.1.1.1.2.4.7.1.4.6.3]
b. 3 Dec
+
J C Mann
d. 29 Oct 1897
11
Margaret Jane Bean
[1.3.1.1.1.2.4.7.1.4.7]
b. 6 Mar 1855
+
Vincent Francis
d. 3 Jul 1897
+
William Housel
10
Synthia Bean
[1.3.1.1.1.2.4.7.1.5]
b. 26 Dec 1807 d. 15 Oct 1816
10
Eliza Bean
[1.3.1.1.1.2.4.7.1.6]
b. 26 Dec 1807 d. 15 Oct 1816
10
Rueben C Bean
[1.3.1.1.1.2.4.7.1.7]
b. 2 Apr 1809
+
Elizabeth
10
Ann Bean
[1.3.1.1.1.2.4.7.1.8]
b. 22 May 1811
10
Mary Bean
[1.3.1.1.1.2.4.7.1.9]
b. 2 May 1813
10
Martha Bean
[1.3.1.1.1.2.4.7.1.10]
b. 15 Dec 1815 d. 6 Jan 1818
9
Anna Hoyt
[1.3.1.1.1.2.4.7.2]
b. 26 Sep 1781 d. 16 Sep 1865
Paulus Tenney
b. 24 Sep 1781 d. 29 Sep 1841
10
Maria Tenney
[1.3.1.1.1.2.4.7.2.1]
b. 4 Jun 1805 d. 1 May 1812
10
Franklin Tenney
[1.3.1.1.1.2.4.7.2.2]
b. 5 Nov 1806 d. 15 Nov 1878
10
Nancy S Tenney
[1.3.1.1.1.2.4.7.2.3]
b. 28 Oct 1808 d. 1885
James French
b. 1 Apr 1815
11
Rebecca Ann French
[1.3.1.1.1.2.4.7.2.3.1]
b. 26 Jan 1838
11
James Paulus French
[1.3.1.1.1.2.4.7.2.3.2]
b. 4 Apr 1840
11
Mary Elizabeth French
[1.3.1.1.1.2.4.7.2.3.3]
b. 24 Aug 1842
+
Oscar E Boyd
b. Abt 1838
11
Jonathan John French
[1.3.1.1.1.2.4.7.2.3.4]
b. 31 Jan 1845
11
Samuel S French
[1.3.1.1.1.2.4.7.2.3.5]
b. 21 Dec 1847 d. 12 Jan 1851
11
William Harris French
[1.3.1.1.1.2.4.7.2.3.6]
b. 29 Oct 1850 d. 11 Jan 1851
11
Solon Tenney French
[1.3.1.1.1.2.4.7.2.3.7]
b. 15 Oct 1851 d. 27 Dec 1908
+
Laura Augusta Shumway
b. 21 Aug 1854
10
Sylvainus Tenny
[1.3.1.1.1.2.4.7.2.4]
b. 6 Oct 1810 d. 12 Oct 1888
Mary Jane Bay
b. 21 Mar 1818
11
Paul Hugh Tenney
[1.3.1.1.1.2.4.7.2.4.1]
b. 1 May 1839 d. 29 Sep 1868
Angeline
b. Abt 1843
12
Mary Tenney
[1.3.1.1.1.2.4.7.2.4.1.1]
b. 1864
12
George S Tenney
[1.3.1.1.1.2.4.7.2.4.1.2]
b. 1866
11
Arkalon Tenney
[1.3.1.1.1.2.4.7.2.4.2]
b. 26 Jun 1841
Margaret Shields
b. Abt 1841
12
Laura A Tenney
[1.3.1.1.1.2.4.7.2.4.2.1]
b. 4 Dec 1860 d. 29 Aug 1876
12
Hosea Eugene Tenney
[1.3.1.1.1.2.4.7.2.4.2.2]
b. 28 Mar 1863 d. 7 Dec 1936 [
=>
]
12
William Sheridan Tenney
[1.3.1.1.1.2.4.7.2.4.2.3]
b. 8 Oct 1865 d. 7 Oct 1876
12
Mary Eliza Tenney
[1.3.1.1.1.2.4.7.2.4.2.4]
b. 21 Feb 1868
12
Leila May Tenney
[1.3.1.1.1.2.4.7.2.4.2.5]
b. 23 Feb 1871
12
Mattie A Tenney
[1.3.1.1.1.2.4.7.2.4.2.6]
b. 25 Oct 1874
12
James Garfield Morton Tenney
[1.3.1.1.1.2.4.7.2.4.2.7]
b. 7 Nov 1881 d. 1970
11
Curtis Monroe Tenney
[1.3.1.1.1.2.4.7.2.4.3]
b. 2 Aug 1847 d. 10 Dec 1850
11
William Lafayette Tenney
[1.3.1.1.1.2.4.7.2.4.4]
b. 30 Apr 1851
Mary Ann Turner
b. Jun 1851
12
Leslie Edward Tenney
[1.3.1.1.1.2.4.7.2.4.4.1]
b. 5 Dec 1873
12
Lieuellon Tenney
[1.3.1.1.1.2.4.7.2.4.4.2]
b. Jun 1875
12
Gracy A Tenney
[1.3.1.1.1.2.4.7.2.4.4.3]
b. Feb 1880
12
William L Tenney
[1.3.1.1.1.2.4.7.2.4.4.4]
b. Feb 1883
12
Minnie M Tenney
[1.3.1.1.1.2.4.7.2.4.4.5]
b. Oct 1885
12
Mary J Tenney
[1.3.1.1.1.2.4.7.2.4.4.6]
b. Jun 1889
12
Hershel A Tenney
[1.3.1.1.1.2.4.7.2.4.4.7]
b. Apr 1891
12
Beatrice Leone Tenney
[1.3.1.1.1.2.4.7.2.4.4.8]
b. 6 Jun 1893
11
Zilpha Tenney
[1.3.1.1.1.2.4.7.2.4.5]
b. 1853 d. 1856
11
Mary Mariah Tenney
[1.3.1.1.1.2.4.7.2.4.6]
b. 4 Sep 1844 d. 15 Jan 1933
Isaac Wood
b. 6 May 1843 d. 1 May 1927
12
Nettie Ambrosia Wood
[1.3.1.1.1.2.4.7.2.4.6.1]
b. 10 Nov 1863 d. 31 Oct 1892
12
Effie Alberta Wood
[1.3.1.1.1.2.4.7.2.4.6.2]
b. 19 Jul 1866 [
=>
]
12
Ivia Jane Wood
[1.3.1.1.1.2.4.7.2.4.6.3]
b. 1870 d. 1963
12
Earnest Doric Wood
[1.3.1.1.1.2.4.7.2.4.6.4]
b. 20 Jan 1874 d. 1939
12
Arkalon John Wood
[1.3.1.1.1.2.4.7.2.4.6.5]
b. 24 Dec 1875 d. 2 Feb 1958 [
=>
]
12
Lillian Grace Wood
[1.3.1.1.1.2.4.7.2.4.6.6]
b. 24 Jan 1879 d. 24 Jan 1879
12
Bessie Kate Wood
[1.3.1.1.1.2.4.7.2.4.6.7]
b. 13 Dec 1881 d. 12 Nov 1977 [
=>
]
12
Zilpha L Wood
[1.3.1.1.1.2.4.7.2.4.6.8]
b. 1883 d. 30 Jun 1986
12
Adda May Wood
[1.3.1.1.1.2.4.7.2.4.6.9]
b. 1883
11
James F Tenney
[1.3.1.1.1.2.4.7.2.4.7]
b. 1856
Martha Ann Austin
b. Jul 1857
12
Maud Tenney
[1.3.1.1.1.2.4.7.2.4.7.1]
b. Oct 1877
12
Sylvanus Tenney
[1.3.1.1.1.2.4.7.2.4.7.2]
b. Mar 1879
12
Martin Tenney
[1.3.1.1.1.2.4.7.2.4.7.3]
b. Jul 1883
12
Frank Tenney
[1.3.1.1.1.2.4.7.2.4.7.4]
b. Dec 1885
12
Otha Tenney
[1.3.1.1.1.2.4.7.2.4.7.5]
b. Aug 1888
12
Edmund Tenney
[1.3.1.1.1.2.4.7.2.4.7.6]
b. Feb 1890
12
Florence M Tenney
[1.3.1.1.1.2.4.7.2.4.7.7]
b. Dec 1894
9
William Hoyt
[1.3.1.1.1.2.4.7.3]
b. 24 Jul 1783 d. 19 Feb 1813
Polly French
b. Abt 1785
10
Freeman Hoyt
[1.3.1.1.1.2.4.7.3.1]
b. 1805
10
Mary French Hoyt
[1.3.1.1.1.2.4.7.3.2]
b. Abt 1809
+
Cheney
b. Abt 1845
10
Sewell Hoyt
[1.3.1.1.1.2.4.7.3.3]
b. Abt 1811
10
William Hoyt
[1.3.1.1.1.2.4.7.3.4]
b. Abt 1813
10
French Hoyt
[1.3.1.1.1.2.4.7.3.5]
b. Abt 1815
9
Sarah Hoyt
[1.3.1.1.1.2.4.7.4]
b. 13 Feb 1786 d. 14 Nov 1862
John Hoyt
b. 2 Dec 1787
10
Sophronia Hoyt
[1.3.1.1.1.2.4.7.4.1]
b. 21 Dec 1810 d. 12 Feb 1889
Joel Blackman
b. 21 Dec 1810 d. 22 Jun 1901
11
True Worthy Blackman
[1.3.1.1.1.2.4.7.4.1.1]
b. 27 Nov 1836 d. 16 Jan 1925
Amelia Fanny Kennedy
b. 10 Jul 1848 d. 8 Dec 1914
12
Albert Joseph Blackman
[1.3.1.1.1.2.4.7.4.1.1.1]
b. 14 Oct 1873 d. 15 Sep 1962
12
Alexander Frances Blackman
[1.3.1.1.1.2.4.7.4.1.1.2]
b. 5 May 1876 [
=>
]
11
John Monroe Blackman
[1.3.1.1.1.2.4.7.4.1.2]
b. 1852 d. 7 Jun 1871
11
Virgil W Blackman
[1.3.1.1.1.2.4.7.4.1.3]
b. 3 Jul 1857 d. 1921
Delle Lucretia Butler
b. Apr 1862 d. 1959
12
Hattie Blackman
[1.3.1.1.1.2.4.7.4.1.3.1]
b. 2 Jan 1891
10
William Hoyt
[1.3.1.1.1.2.4.7.4.2]
b. 12 Oct 1813
+
Mrs Hoyt
10
Samuel True Hoyt
[1.3.1.1.1.2.4.7.4.3]
b. Abt 1814
10
True Worthy Hoyt
[1.3.1.1.1.2.4.7.4.4]
b. 31 Aug 1815 d. 1900
Phebe Ann Jameson
b. 1820
11
Phoebe Sophronia Hoyt
[1.3.1.1.1.2.4.7.4.4.1]
b. 12 May 1847 d. 4 Aug 1849
11
Sarah Elizabeth Hoyt
[1.3.1.1.1.2.4.7.4.4.2]
b. 16 Aug 1850 d. 22 Jan 1855
11
True Worthy Hoit
[1.3.1.1.1.2.4.7.4.4.3]
b. 15 May 1853
+
Louisa Catherine M. Murenberg
11
Elisabeth Jamison Hoit
[1.3.1.1.1.2.4.7.4.4.4]
b. 16 Jun 1856
+
William H S Thorburn
11
Homer A Hoit
[1.3.1.1.1.2.4.7.4.4.5]
b. 17 Dec 1858 d. 28 Feb 1923
+
Florence E Hickey
11
Fanny Story Hoyt
[1.3.1.1.1.2.4.7.4.4.6]
b. 19 Oct 1861
10
Albert Lewis Hoyt
[1.3.1.1.1.2.4.7.4.5]
b. 23 Dec 1822 d. 10 Aug 1843
8
Asa Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.8]
b. 29 Mar 1764 d. 25 Feb 1829
Irene Carpenter
b. 28 Jan 1766 d. 5 Oct 1846
9
Derick Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.8.1]
b. 22 May 1788 d. Abt 1846
Rachael Roberts
b. 1800 d. Aft 1860
10
Caroline Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.8.1.1]
b. 1833 d. Aft 1860
W L Evans
b. 1827 d. Aft 1860
11
Anna B Evans
[1.3.1.1.1.2.4.8.1.1.1]
b. 1852 d. Aft 1860
9
Sophia Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.8.2]
b. 5 Oct 1790 d. 4 Feb 1841
Oren Hall
b. 1789 d. Dec 1820
10
Sophia Edna Hall
[1.3.1.1.1.2.4.8.2.1]
b. 1 Apr 1809 d. 1870
Edwin Thomson
b. 1808 d. Abt 1857
11
Mortimer Neal Thomson
[1.3.1.1.1.2.4.8.2.1.1]
b. 2 Sep 1831 d. 25 Jun 1875
Anna Houston VanCleve
b. 1840 d. Dec 1858
12
Mark VanCleve Thomson
[1.3.1.1.1.2.4.8.2.1.1.1]
b. 1859
Grace Harrington Eldredge
b. 24 Feb 1841 d. 13 Dec 1862
12
Ethel Thomson
[1.3.1.1.1.2.4.8.2.1.1.2]
b. 1 Dec 1862 d. 1944
11
Clifford Thomson
[1.3.1.1.1.2.4.8.2.1.2]
b. 15 Apr 1834 d. 29 Sep 1912
Sarah Maria Dutton
b. 1844 d. 23 Oct 1934
12
Clifford Thomson
[1.3.1.1.1.2.4.8.2.1.2.1]
b. 1868 d. Bef 1880
12
Florence F Thomson
[1.3.1.1.1.2.4.8.2.1.2.2]
b. 13 Jun 1869 d. 27 Jul 1939
12
Winifred E Thomson
[1.3.1.1.1.2.4.8.2.1.2.3]
b. 22 Feb 1871 d. 26 Jun 1950
10
Edwin Oscar Hall
[1.3.1.1.1.2.4.8.2.2]
b. 21 Oct 1810 d. 19 Sep 1883
Sarah Lyon Williams
b. 27 Oct 1812 d. 15 Aug 1876
11
Sophia Elizabeth Hall
[1.3.1.1.1.2.4.8.2.2.1]
b. 4 Jul 1836 d. 26 May 1863
William White
b. 28 Feb 1837 d. 8 May 1896
12
Lucy Sophia White
[1.3.1.1.1.2.4.8.2.2.1.1]
b. 25 Mar 1861 d. 25 Apr 1891 [
=>
]
12
Edwin Oscar White
[1.3.1.1.1.2.4.8.2.2.1.2]
b. 6 May 1863 d. 9 Jun 1940 [
=>
]
11
Caroline Alice Hall
[1.3.1.1.1.2.4.8.2.2.2]
b. 5 Nov 1839 d. 29 Jan 1868
11
William Wisner Hall
[1.3.1.1.1.2.4.8.2.2.3]
b. 1 Jun 1841 d. 23 May 1910
Elizabeth Archer VanCleve
b. 25 Nov 1846 d. 27 Jun 1918
12
William Sibley Hall
[1.3.1.1.1.2.4.8.2.2.3.1]
b. 30 Jan 1867 d. 19 Oct 1868
12
Horatio VanCleve Hall
[1.3.1.1.1.2.4.8.2.2.3.2]
b. 15 Jan 1871 d. 20 Aug 1889
12
Charlotte VanCleve Hall
[1.3.1.1.1.2.4.8.2.2.3.3]
b. 31 Jul 1876 d. 23 May 1969
12
Theodore Seymour Hall
[1.3.1.1.1.2.4.8.2.2.3.4]
b. 16 Feb 1880 d. 6 Mar 1963 [
=>
]
12
Edwin Oscar Hall
[1.3.1.1.1.2.4.8.2.2.3.5]
b. 30 May 1881 d. 28 Oct 1946 [
=>
]
12
Florence Hall
[1.3.1.1.1.2.4.8.2.2.3.6]
b. 18 May 1884 d. 9 Mar 1982 [
=>
]
12
Philip Cushman Hall
[1.3.1.1.1.2.4.8.2.2.3.7]
b. 11 Dec 1886 d. 28 Apr 1972
11
Cornelia Hall
[1.3.1.1.1.2.4.8.2.2.4]
b. 25 Aug 1842 d. 27 Apr 1911
Peter Cushman Jones
b. 10 Dec 1837 d. 23 Apr 1922
12
Edwin Austin Jones
[1.3.1.1.1.2.4.8.2.2.4.1]
b. 11 May 1863 d. 10 Jul 1898 [
=>
]
12
Ada Jones
[1.3.1.1.1.2.4.8.2.2.4.2]
b. 28 Oct 1869 d. 28 Jun 1950 [
=>
]
12
Alice Hall Jones
[1.3.1.1.1.2.4.8.2.2.4.3]
b. 2 Jan 1880 d. 10 Oct 1974
+
Mary Lyon Dame
b. 6 Oct 1848 d. 16 Mar 1908
10
Asa Sibley Hall
[1.3.1.1.1.2.4.8.2.3]
b. 23 Apr 1818
Joseph Willard Seymour
b. 29 Mar 1781 d. 25 Jan 1867
10
Oren T Seymour
[1.3.1.1.1.2.4.8.2.4]
b. 1824
10
Mary E. Seymour
[1.3.1.1.1.2.4.8.2.5]
b. Abt 1825 d. Aft 1850
10
Theodore S. Seymour
[1.3.1.1.1.2.4.8.2.6]
b. 1 Jul 1828 d. 1902
9
Lucy Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.8.3]
b. 21 Jul 1792 d. 18 Jul 1795
9
Levi Waite Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.8.4]
b. 4 Mar 1801 d. 13 Aug 1844
Nancy Ann Remington
b. 18 Sep 1801 d. 9 Jan 1870
10
Augustus Furburt Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.8.4.1]
b. 15 Jul 1827
Mary Williamsen Ogden
b. 20 May 1838 d. 15 Jan 1890
11
Herman Clark Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.8.4.1.1]
b. 22 Nov 1860
10
Amanda Maria Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.8.4.2]
b. 25 Oct 1829 d. 31 Mar 1861
John Francis Hoyt
b. 18 Oct 1816
11
Harriet M Hoyt
[1.3.1.1.1.2.4.8.4.2.1]
b. 19 Oct 1849
10
William Wisner Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.8.4.3]
b. 4 Feb 1831 d. 30 Jun 1870
+
Helen Jane Wilcox
b. 31 Aug 1831
10
Harriet Remington Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.8.4.4]
b. 12 Jul 1833 d. Aug 1844
10
George Ainsworth Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.8.4.5]
b. 13 Jun 1834 d. 29 Dec 1856
10
Levi Edwin Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.8.4.6]
b. 8 Sep 1839 d. 29 Oct 1900
Sarah Ella Martling
b. Oct 1852 d. 28 Dec 1932
11
Lucy M Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.8.4.6.1]
b. 1876 d. 1888
11
William W Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.8.4.6.2]
b. Dec 1877
Florence Z Parsons
b. 1883
12
Edwin Gerald Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.8.4.6.2.1]
b. 4 Apr 1906 d. Dec 1963
12
Frederick Warren Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.8.4.6.2.2]
b. 1907 d. 1941
12
William Parsons Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.8.4.6.2.3]
b. 1909 d. 1967
12
George E Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.8.4.6.2.4]
b. 1914
11
George Edwin Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.8.4.6.3]
b. 24 Jun 1881
9
Mary Ann Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.8.5]
b. 18 Dec 1804 d. 18 Oct 1870
Edwin Scrantom
b. 9 May 1803 d. 3 Oct 1880
10
Stella Benton Scrantom
[1.3.1.1.1.2.4.8.5.1]
b. 12 Jan 1827
+
Galusha Phillips
b. 27 Apr 1820 d. 1880
10
Adrian George Scrantom
[1.3.1.1.1.2.4.8.5.2]
b. 26 Oct 1828 d. 1880
+
Mary Sheldon
b. Abt 1832
+
Charlotta
d. 1880
+
Helen Jane Wilcox
b. 31 Aug 1831 d. Abt 1900
10
Cora Irene Scrantom
[1.3.1.1.1.2.4.8.5.3]
b. 28 Jun 1830 d. 31 Dec 1858
John E Sabine
b. Abt 1826 d. 7 Jul 1854
11
Cora Lovisa Sabine
[1.3.1.1.1.2.4.8.5.3.1]
b. 30 Jan 1850
11
Mary Irene Sabine
[1.3.1.1.1.2.4.8.5.3.2]
b. 8 Jan 1853
Franklin Earl Childs
b. 16 Oct 1848
12
Emalita Phillips Childs
[1.3.1.1.1.2.4.8.5.3.2.1]
b. 21 Oct 1879
12
Daniel B Childs
[1.3.1.1.1.2.4.8.5.3.2.2]
b. 18 Sep 1881
11
Sibly Phillips Sabine
[1.3.1.1.1.2.4.8.5.3.3]
b. 23 Dec 1854
George Williams
b. 24 Nov 1831 d. 10 Feb 1895
11
Child Williams
[1.3.1.1.1.2.4.8.5.3.4]
b. 31 Dec 1858 d. 31 Dec 1858
10
Edwina Jane Scrantom
[1.3.1.1.1.2.4.8.5.4]
b. 24 Sep 1832 d. Abt 1839
10
Hamlet Edwin Scrantom
[1.3.1.1.1.2.4.8.5.5]
b. Abt 1833 d. Abt 1833
10
Beulah Mary Scrantom
[1.3.1.1.1.2.4.8.5.6]
b. 15 Jan 1835 d. 1 Jan 1900
Isaac H Weaver
b. Abt 1831 d. Bef 1867
11
Edwin James Weaver
[1.3.1.1.1.2.4.8.5.6.1]
b. 1857 d. 12 Aug 1874
Ensley Mills Smith
b. 8 Aug 1828 d. 7 May 1886
11
Emmalita A Smith
[1.3.1.1.1.2.4.8.5.6.2]
b. 12 Apr 1868 d. 29 Sep 1879
11
Mary Elizabeth Smith
[1.3.1.1.1.2.4.8.5.6.3]
b. 6 Jul 1870 d. 13 Oct 1879
11
Ensley Boyd Smith
[1.3.1.1.1.2.4.8.5.6.4]
b. 10 Jan 1876 d. 7 Aug 1956
+
Stella Louisa Jerome
b. 6 May 1876 d. 8 Feb 1955
10
Edwin Levi Scrantom
[1.3.1.1.1.2.4.8.5.7]
b. Abt 1837 d. Abt 1837
10
Clifford Sibley Scrantom
[1.3.1.1.1.2.4.8.5.8]
b. Abt 1841 d. Abt 1844
10
Melford Clark Scrantom
[1.3.1.1.1.2.4.8.5.9]
b. 4 Nov 1844 d. Abt 1845
10
Bertha Sibley Scranton
[1.3.1.1.1.2.4.8.5.10]
b. 29 Nov 1848
9
George Ainsworth Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.8.6]
b. 9 Apr 1809 d. 1 Jun 1836
9
Daughter Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.8.7]
c. 1 Oct 1809 d. 1809
8
Jonathan Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.9]
b. 8 May 1766 d. 20 Feb 1823
Mary Davis
b. 24 Feb 1768 d. 23 Jun 1840
9
Davis Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.9.1]
b. 29 Nov 1788 d. 21 Nov 1828
Cynta Fisher
b. Abt 1797 d. 6 Jul 1874
10
Nelson Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.9.1.1]
b. 4 Mar 1820 d. 10 Mar 1850
10
Franklin Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.9.1.2]
b. 1 Oct 1821 d. 1878
Julia Badger Leavitt
b. 29 Jul 1826 d. 28 Jan 1864
11
Mary Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.9.1.2.1]
b. 1847
11
Frederick M Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.9.1.2.2]
b. Jun 1849 d. 2 Oct 1912
11
Davis Origin Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.9.1.2.3]
b. 28 Jun 1853 d. 22 May 1913
11
George F Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.9.1.2.4]
b. Sep 1853
11
Walter Frank Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.9.1.2.5]
b. Sep 1857 d. 4 Jun 1911
Clara Greenwood Beecher
b. 6 Feb 1857 d. 21 Sep 1949
12
Chester L Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.9.1.2.5.1]
b. 1882 d. 1884
12
Maurice Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.9.1.2.5.2]
b. 1886 d. 1894
12
Frank Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.9.1.2.5.3]
b. 1888 d. 1890
12
Hazel Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.9.1.2.5.4]
b. 27 Jun 1892 d. 10 Feb 1948
12
Gladys L Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.9.1.2.5.5]
b. 1896 d. 1928
11
John L Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.9.1.2.6]
b. 1859
Ellen W Floyd
b. 1836 d. 1 Jul 1878
11
Ernia M Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.9.1.2.7]
b. Jun 1878 d. 12 Jul 1878
11
Ena L Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.9.1.2.8]
b. Jun 1878 d. 30 Jun 1878
10
Laura Messenger Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.9.1.3]
b. 6 Dec 1822 d. 13 Jan 1861
10
Mary Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.9.1.4]
b. 15 Apr 1825 d. 21 Aug 1826
10
Martha Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.9.1.5]
b. 18 Jun 1826 d. Sep 1826
10
Mary Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.9.1.6]
b. 7 Aug 1827 d. 16 Oct 1840
10
Caroline F Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.9.1.7]
b. 14 Dec 1828 d. 7 Apr 1853
+
Cyrus Harris
9
Mary Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.9.2]
b. 13 Apr 1792 d. 9 Nov 1844
Augustine White
b. 19 Jan 1777
10
Mary Ann White
[1.3.1.1.1.2.4.9.2.1]
b. 19 Apr 1812 d. 12 May 1823
10
Eliza Malvina White
[1.3.1.1.1.2.4.9.2.2]
b. 30 Nov 1814 d. 7 Apr 1858
+
Henry W Nichols
10
Cynthia Sibley White
[1.3.1.1.1.2.4.9.2.3]
b. 8 May 1818
10
Augusta Holven White
[1.3.1.1.1.2.4.9.2.4]
b. 28 Jan 1821
+
Daniel Scott
10
Lucy Violy White
[1.3.1.1.1.2.4.9.2.5]
b. 20 Oct 1824 d. Jul 1845
10
John S White
[1.3.1.1.1.2.4.9.2.6]
b. 2 Jul 1827
+
Emilie Jouret
10
Davis J White
[1.3.1.1.1.2.4.9.2.7]
b. 27 Jan 1833
9
Jonathan W Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.9.3]
b. 13 Aug 1800 d. 26 Sep 1829
Brooksey Case
b. 30 Sep 1804 d. 15 Mar 1829
10
Albert C Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.9.3.1]
b. 3 Jun 1828 d. Feb 1852
8
Benjamin Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.10]
b. 29 Apr 1768 d. 2 Oct 1829
Zilpah Davis
b. 13 Apr 1771 d. 16 May 1824
9
Samuel Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.10.1]
b. 30 Nov 1792 d. 4 Mar 1858
Lucinda Holbrock
b. 19 Mar 1806 d. 2 Mar 1830
10
Giles H Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.10.1.1]
b. 26 May 1825 d. 10 Jun 1825
10
Morella Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.10.1.2]
b. 19 Jun 1827 d. 31 Jul 1849
10
Lucinda Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.10.1.3]
b. 12 Jul 1829 d. 4 Sep 1854
Almira Dixon
b. 3 Apr 1807
10
Elizabeth H Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.10.1.4]
b. 20 Nov 1833
+
Joseph Fisk
10
Mary Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.10.1.5]
b. 16 Jan 1838 d. 17 Aug 1839
10
Helen Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.10.1.6]
b. 23 Sep 1842 d. 3 Feb 1844
10
George H Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.10.1.7]
b. 25 Aug 1845
+
Theodocia Townsend
9
Patty Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.10.2]
b. 6 Feb 1799 d. 12 Jul 1805
9
Nancy Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.10.3]
b. 7 Feb 1806 d. 14 Feb 1806
9
Hiram Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.10.4]
b. 6 Feb 1807 d. 12 Jul 1888
Elizabeth Maria Tinker
b. 11 Aug 1815 d. 11 Jul 1903
10
Zilpha Louisa Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.10.4.1]
b. 7 Dec 1833 d. 16 Jun 1868
Hobart Ford Atkinson
b. 5 Oct 1825 d. 14 Aug 1908
11
Marie Louise Atkinson
[1.3.1.1.1.2.4.10.4.1.1]
b. 24 Feb 1864 d. 29 Oct 1940
+
Gilman Henry Hubbell Perkins
b. 2 Nov 1861 d. 12 Mar 1894
+
Ernest Russell Willard
b. 11 Mar 1854 d. 6 May 1937
11
Elizabeth Storer Atkinson
[1.3.1.1.1.2.4.10.4.1.2]
b. Abt 1866 bur. 16 Feb 1945
10
Giles Benjamin Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.10.4.2]
b. 8 Apr 1841 d. 14 Mar 1843
10
Hiram Watson Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.10.4.3]
b. 2 Mar 1845 d. 28 Jun 1932
Margaret Durbin Harper
b. 14 Feb 1852 d. 28 May 1939
11
Margaret Harper Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.10.4.3.1]
b. 14 Dec 1873 d. 30 Nov 1874
11
Hiram Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.10.4.3.2]
b. 24 Jul 1875 d. 12 Apr 1886
11
John Durbin Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.10.4.3.3]
b. 3 Nov 1883 d. 18 Sep 1888
11
Fletcher Harper Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.10.4.3.4]
b. 5 Apr 1885 d. 24 Apr 1959
Georgianna Harding Farr
b. 30 May 1887 d. 10 Jun 1980
12
Jane Harper Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.10.4.3.4.1]
b. 27 Jul 1918 d. 5 Feb 2006
11
Margaret Urling Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.10.4.3.5]
b. 17 Jan 1893 d. 3 Apr 1951
+
O'Donnell Iselin
b. 6 Oct 1884 d. 7 Nov 1971
10
Emily Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.10.4.4]
b. 10 May 1855 d. 8 Feb 1945
Isaac Seymour Averill
b. 21 Jun 1850 d. 25 Oct 1909
11
Elizabeth Louise Averell
[1.3.1.1.1.2.4.10.4.4.1]
b. 25 Jan 1877 d. 2 Apr 1886
11
James G Averell
[1.3.1.1.1.2.4.10.4.4.2]
b. 23 Dec 1877 d. 30 Nov 1904
James Sibley Watson
b. 11 Mar 1860 d. 1951
11
James Sibley "Sibley" Watson, Jr
[1.3.1.1.1.2.4.10.4.4.3]
b. 10 Aug 1894 d. 31 Mar 1982
Hildegarde Lasell
b. 28 Dec 1888 d. 1976
12
Michael Lasell Watson
[1.3.1.1.1.2.4.10.4.4.3.1]
b. 2 Jan 1918 d. 26 Nov 2012
12
Jeanne Iseult Watson
[1.3.1.1.1.2.4.10.4.4.3.2]
b. 14 Dec 1921 d. 9 Mar 1991
8
Soloman Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.11]
b. 17 Nov 1769
Sally Stockwell
b. 21 Jan 1774
9
Stephen Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.11.1]
b. 12 Dec 1792
9
Nancy Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.11.2]
b. 19 Jan 1797
+
Nathan Muzzy
b. 24 Dec 1792 d. 23 Jun 1858
9
Heister Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.11.3]
b. 19 Jun 1799
9
Lewis Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.11.4]
b. 8 Jul 1801
9
Stephen Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.11.5]
b. 26 Jul 1805
Charlotte Reed Peirce
b. 7 Jul 1811 d. 22 Aug 1882
10
John Reed Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.11.5.1]
b. 18 Apr 1838
10
George H Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.11.5.2]
b. 17 Aug 1841
+
Emma J Gould
b. 8 Jul 1850
10
Martha P Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.11.5.3]
b. 16 Nov 1843
10
Mary Charlotte Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.11.5.4]
b. 18 May 1847
Albert Marritt Phillips
b. 9 Oct 1843
11
Clara Willis Phillips
[1.3.1.1.1.2.4.11.5.4.1]
b. 13 May 1884
10
Clara Sophronia Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.11.5.5]
b. 8 Nov 1849
Otis Sumner Pond
b. 3 Nov 1846
11
Arthur N Pond
[1.3.1.1.1.2.4.11.5.5.1]
b. 1 Mar 1873
+
Mary J
b. Jun 1872
11
Herbert Carroll Pond
[1.3.1.1.1.2.4.11.5.5.2]
b. 26 May 1877 d. 7 Dec 1930
Mary Jane Leake
b. 1884 d. 23 May 1970
12
Elsie Clara Margaret Pond
[1.3.1.1.1.2.4.11.5.5.2.1]
b. 21 Nov 1901 d. 6 Sep 1986
12
Adelaide E Pond
[1.3.1.1.1.2.4.11.5.5.2.2]
b. 1903
9
Solomon Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.11.6]
b. 14 Jun 1808
9
John Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.11.7]
b. 20 Feb 1818 d. 17 Aug 1824
8
Polly Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.12]
b. 4 Dec 1771
Abner C Cummings
b. 9 Oct 1770 d. 1800
9
Nancy Cummings
[1.3.1.1.1.2.4.12.1]
b. 5 Nov 1795
John Putnam
b. Abt 1792
10
Dulcina Putnam
[1.3.1.1.1.2.4.12.1.1]
b. 12 Dec 1813 d. 20 Jul 1816
10
Harriet Putnam
[1.3.1.1.1.2.4.12.1.2]
b. 20 Mar 1815 d. 20 Jul 1816
10
Jane Putnam
[1.3.1.1.1.2.4.12.1.3]
b. 1 Nov 1816
Walters Putnam
b. 16 Mar 1817
11
Sarah Jane Putnam
[1.3.1.1.1.2.4.12.1.3.1]
b. 1 Nov 1841
11
Nancy L Putnam
[1.3.1.1.1.2.4.12.1.3.2]
b. 15 Aug 1845
+
James W Davis
11
Marble Putnam
[1.3.1.1.1.2.4.12.1.3.3]
b. 19 Aug 1847
Evaline Inez Waters
b. 10 Sep 1850
12
Justin Marble Putnam
[1.3.1.1.1.2.4.12.1.3.3.1]
b. 27 Feb 1873
12
Julia Rosina Putnam
[1.3.1.1.1.2.4.12.1.3.3.2]
b. 22 Aug 1875 d. Mar 1968 [
=>
]
12
Charles Wesley Putnam
[1.3.1.1.1.2.4.12.1.3.3.3]
b. 9 Mar 1880
12
Jane Waters Putnam
[1.3.1.1.1.2.4.12.1.3.3.4]
b. 1 Sep 1882
11
Martha Waters Putnam
[1.3.1.1.1.2.4.12.1.3.4]
b. 3 Nov 1849 d. 8 Feb 1856
11
Henry Waters Putnam
[1.3.1.1.1.2.4.12.1.3.5]
b. 1 Oct 1855
10
John Perry Putnam
[1.3.1.1.1.2.4.12.1.4]
b. 27 Mar 1818
10
Ira Putnam
[1.3.1.1.1.2.4.12.1.5]
b. 15 Nov 1819 d. 12 May 1821
10
Ephraim Laughton Putnam
[1.3.1.1.1.2.4.12.1.6]
b. 30 Apr 1821 d. 3 Dec 1822
9
Clarissa Cummings
[1.3.1.1.1.2.4.12.2]
b. 18 Apr 1796 d. 1838
Creenfield Pote Merrill
b. 26 Aug 1794 d. 27 Mar 1876
10
Edward Pote Merrill
[1.3.1.1.1.2.4.12.2.1]
b. 22 Oct 1820 d. 1870
+
Olive B Lincoln
b. 1823
10
Elizabeth C Merrill
[1.3.1.1.1.2.4.12.2.2]
b. 26 Feb 1822 d. 16 Dec 1839
10
Greenfield Merrill
[1.3.1.1.1.2.4.12.2.3]
b. 14 Dec 1825
10
Samuel Merrill
[1.3.1.1.1.2.4.12.2.4]
b. 28 Oct 1832 d. 1912
10
Creenfield Merrill
[1.3.1.1.1.2.4.12.2.5]
b. 14 Dec 1834
10
Daniel Cummings Merrill
[1.3.1.1.1.2.4.12.2.6]
b. 20 Mar 1837 d. 1925
+
Mary A Noyes
b. 23 May 1841 d. 28 Feb 1893
8
Artamus Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.13]
b. 9 Jul 1773 d. 10 Aug 1777
8
Nahum Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.14]
b. 11 Sep 1775 d. 12 Sep 1796
8
Sally Sibley
[1.3.1.1.1.2.4.15]
b. 6 Jun 1779 d. 21 Mar 1833
Amasa Cummings
b. 17 Jan 1778 d. 22 Mar 1836
9
Abner Cummings
[1.3.1.1.1.2.4.15.1]
b. 1 Jan 1808
9
Sarah Ann Cummings
[1.3.1.1.1.2.4.15.2]
b. 22 Oct 1812
9
Nahum Sibley Cummings
[1.3.1.1.1.2.4.15.3]
b. 7 Jan 1816
+
Hannah Amidon
b. Abt 1730 d. 5 Jun 1822
6
Jonathan Sibley
[1.3.1.1.1.3]
b. 1 May 1690 d. Abt 1733
Mary Cutler
b. 19 Mar 1691 d. 1734
7
Martha Sibley
[1.3.1.1.1.3.1]
b. 10 Jul 1731
6
Hannah Sibley
[1.3.1.1.1.4]
c. 9 May 1695 d. 8 Feb 1731
Ebenezer Daggett
b. 22 Nov 1693 d. 8 Apr 1762
7
Ebenezer Daggett
[1.3.1.1.1.4.1]
b. 13 Apr 1723 d. Bef 3 Aug 1761
7
Thomas Daggett
[1.3.1.1.1.4.2]
b. 21 Apr 1725 d. 28 Nov 1758
Martha Stockwell
b. 25 Mar 1724
8
Captain John Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.1]
b. 15 Sep 1748 d. 8 Feb 1816
Mary Stevens
b. 1749
9
Thomas Dagget
[1.3.1.1.1.4.2.1.1]
b. 5 Aug 1776
Ruth Record
c. 25 Jan 1777
10
Elisha Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.1.1.1]
b. Abt 1801 d. Abt 1881
10
Ruth Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.1.1.2]
b. Abt 1804 d. 1881
10
Thomas Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.1.1.3]
b. Abt 1806
9
John Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.1.2]
b. 14 Oct 1778 d. 6 Jan 1824
Sarah Record
b. 1780 d. 25 Oct 1821
10
Luther Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.1.2.1]
b. 19 Nov 1800
10
Betsey Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.1.2.2]
b. 25 Nov 1802
John Harris
b. 31 Dec 1799
11
Palina Harris
[1.3.1.1.1.4.2.1.2.2.1]
b. Abt 1831
11
Sarah Harris
[1.3.1.1.1.4.2.1.2.2.2]
b. Abt 1833
11
Benton Harris
[1.3.1.1.1.4.2.1.2.2.3]
b. Abt 1834
11
Amelia Harris
[1.3.1.1.1.4.2.1.2.2.4]
b. Abt 1836
11
Almira Harris
[1.3.1.1.1.4.2.1.2.2.5]
b. Abt 1839
10
Calvin Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.1.2.3]
b. 24 Jan 1806 d. 1 Jul 1832
Laura Mower
b. 24 May 1805 d. 21 Mar 1863
11
Luther S Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.1.2.3.1]
b. 3 Jan 1826 d. 29 Nov 1873
Almira Larrabee
b. 28 Jan 1825
12
Frank W Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.1.2.3.1.1]
b. 1850
12
Emma J Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.1.2.3.1.2]
b. 1852
12
Ella A Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.1.2.3.1.3]
b. 1860 d. 28 Sep 1873
11
Calvin K Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.1.2.3.2]
b. 22 Feb 1828
+
Rebecca E Cross
b. 1830
11
Henry T Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.1.2.3.3]
b. 13 Feb 1830
11
Luella Jane Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.1.2.3.4]
b. 15 Jul 1832
11
Laura Ann Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.1.2.3.5]
b. 15 Jul 1832 d. 17 Sep 1887
10
Sarah Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.1.2.4]
b. 27 Dec 1809 d. 30 Jun 1832
10
Lucy Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.1.2.5]
b. 15 Aug 1812
10
Anna Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.1.2.6]
b. 26 Nov 1814
10
John Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.1.2.7]
b. 16 Nov 1817
10
Silas Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.1.2.8]
b. 20 Jun 1821
9
Sarah Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.1.3]
b. 2 Apr 1780 d. 1873
Captain Samuel Bates
b. Abt 1776
10
Florentine Bates
[1.3.1.1.1.4.2.1.3.1]
b. Abt 1802
10
Simeon Bates
[1.3.1.1.1.4.2.1.3.2]
b. Abt 1804
10
Marilla Bates
[1.3.1.1.1.4.2.1.3.3]
b. Abt 1806
10
Sarah Bates
[1.3.1.1.1.4.2.1.3.4]
b. Abt 1808
9
Simeon Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.1.4]
b. Abt 1782
9
Simon Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.1.5]
b. 1786 d. 1807
9
Captain Aaron Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.1.6]
b. 4 Mar 1787 d. 1 Feb 1862
Almira Dearborn
b. 7 May 1789 d. 11 Mar 1830
10
Greenlief Dearborn Quincy Adams Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.1.6.1]
b. 10 Nov 1818 d. 23 Jul 1854
10
Converse Rollin Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.1.6.2]
b. 14 Mar 1820
Anna F Packard Bailey
b. 11 Jun 1845
11
Emma Rose Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.1.6.2.1]
b. 4 Dec 1880
10
Simon Dearborn Alfred Pierce Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.1.6.3]
b. 19 Sep 1822 d. 11 Aug 1840
10
Molly Dearborn Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.1.6.4]
b. 13 Apr 1826 d. 23 Apr 1826
10
Almira Augusta Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.1.6.5]
b. 28 Sep 1827 d. 27 Mar 1865
+
Isaac Cotton Merrill
b. Abt 1823
Dorcas C Dearborn
b. 13 Jun 1796 d. 24 Mar 1869
10
Ebenezer Sanborn Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.1.6.6]
b. 30 Sep 1831
10
John Carroll Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.1.6.7]
b. 29 Jul 1833 d. 12 Dec 1902
Abigail Chandler Fogg
b. 18 Jul 1851 d. 4 Sep 1877
11
Aaron Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.1.6.7.1]
b. 19 Dec 1871
11
Augusta Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.1.6.7.2]
b. 3 Aug 1873
11
Walter Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.1.6.7.3]
b. Jan 1875
10
Mary Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.1.6.8]
b. 9 Jan 1835 d. 1 Oct 1861
10
Brigadier General Aaron Simon Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.1.6.9]
b. 14 Jan 1837 d. 14 May 1931
Martha Rosetta Bradford
b. 11 Sep 1840
11
Mary Augusta Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.1.6.9.1]
b. 21 Oct 1868
11
Royal Bradford Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.1.6.9.2]
b. 13 Nov 1870
11
Alice Southworth Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.1.6.9.3]
b. 11 Aug 1872
11
Helen Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.1.6.9.4]
b. 1 Sep 1881
9
Mary Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.1.7]
b. 5 Jul 1789
Luther Robbins
b. Abt 1785
10
Louisiana Robbins
[1.3.1.1.1.4.2.1.7.1]
b. Abt 1811
10
Survetus Robbins
[1.3.1.1.1.4.2.1.7.2]
b. Abt 1813
10
Mary Robbins
[1.3.1.1.1.4.2.1.7.3]
b. Abt 1815
10
John Robbins
[1.3.1.1.1.4.2.1.7.4]
b. Abt 1817
10
Clementine Robbins
[1.3.1.1.1.4.2.1.7.5]
b. Abt 1819
+
Sarah Jones
b. 26 Oct 1749 d. Bef 1775
8
Mary Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.2]
b. 29 Mar 1750 d. Aft 25 Sep 1826
Seth Corbett Jones
b. 21 Mar 1748 d. 14 Apr 1827
9
Samuel Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1]
b. 5 Aug 1773 d. 24 Aug 1846
Matilda Davis
b. 13 Aug 1777 d. Aft 1820
10
Reuben Davis Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.1]
b. 30 Jul 1798 d. 22 Feb 1866
Harriet Dennis Ryan
b. 10 Mar 1799 d. 30 Dec 1891
11
Albert Davis Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.1.1]
b. 29 Jul 1824 d. 5 Sep 1889
Sarah L Frisbie
b. 14 Oct 1837 d. 1 Sep 1914
12
Albert F Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.1.1.1]
b. Oct 1858 d. 8 Dec 1931
11
Sarah Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.1.2]
b. 26 Jun 1826 d. 24 Sep 1827
11
Julia Madeline Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.1.3]
b. 7 Jun 1828 d. 9 Jan 1916
Edward H Sears
b. 14 Dec 1819 d. 16 Jun 1900
12
Caroline Matilda Sears
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.1.3.1]
b. 1 Feb 1854 d. 11 Oct 1854
12
Edward Jones Sears
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.1.3.2]
b. 19 Jun 1858 d. 20 May 1883
12
Arthur Davis Sears
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.1.3.3]
b. 7 Jan 1861 d. 7 Aug 1861
12
Hattie Cornelia Sears
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.1.3.4]
b. 30 Dec 1862 d. 7 Apr 1863
12
Jennie Madeline Sears
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.1.3.5]
b. 20 Dec 1864 d. 25 Dec 1887 [
=>
]
12
Julia Louise Sears
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.1.3.6]
b. 22 Sep 1867 d. 24 Jul 1868
12
Maud Elizabeth Sears
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.1.3.7]
b. 14 Aug 1875 d. 15 Feb 1909 [
=>
]
11
Henry Orlando Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.1.4]
b. 25 Feb 1831 d. Bef 1870
Cornelia Eliza Frisbie
b. 8 Aug 1833 d. 2 Apr 1899
12
Harry O Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.1.4.1]
b. 16 Oct 1859 d. 24 Oct 1943 [
=>
]
11
Caroline Matilda Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.1.5]
b. 25 Jul 1834 d. 15 Sep 1848
11
Jonathan Edward Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.1.6]
b. 16 Jun 1840 d. 15 Aug 1855
10
Seth Corbitt Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.2]
b. 23 Sep 1800 d. 21 Jul 1867
Isabel Richardson
b. 29 Jun 1801 d. 29 Mar 1885
11
Seth John Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.2.1]
b. 6 Sep 1824 d. 24 Feb 1831
11
William Richardson Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.2.2]
b. 12 Aug 1825 d. 19 Apr 1895
Mary Ann Tryon
b. 1823 d. 5 Jun 1864
12
Child Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.2.2.1]
b. 3 Sep 1847 d. 3 Sep 1847
12
Child Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.2.2.2]
b. 21 Feb 1853 d. 21 Feb 1853
12
Julia L Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.2.2.3]
b. Feb 1854 d. 25 Aug 1862
12
James C Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.2.2.4]
b. Nov 1856 d. 20 Jan 1863
12
Charles C Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.2.2.5]
b. Nov 1858 d. 17 Aug 1862
11
Morris Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.2.3]
b. 12 Mar 1828 d. 2 Feb 1829
11
Henry George Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.2.4]
b. 29 Jun 1830 d. 21 Jan 1888
Francis Mathilda Hayden
b. Aug 1832 d. 15 Aug 1884
12
Seth Corby Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.2.4.1]
b. 1854 d. 3 Aug 1929
12
Francis Henry Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.2.4.2]
b. 1862
12
George Henry Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.2.4.3]
b. 1864 [
=>
]
11
Hobart Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.2.5]
b. 4 Jun 1832 d. 14 Mar 1887
Isabel Jones
b. 16 Jan 1836 d. 6 Mar 1913
12
Caroline Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.2.5.1]
b. 1857 d. 1870
12
William Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.2.5.2]
b. 1859 d. Bef 1870
12
Alfred Hobart Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.2.5.3]
b. 14 Nov 1862 d. 28 Aug 1922 [
=>
]
12
Mary E Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.2.5.4]
b. 1867 d. Abt 1897 [
=>
]
11
Heber C Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.2.6]
b. 24 Dec 1835 d. 17 Apr 1896
Mary Elizabeth Bull
b. 31 Oct 1834
12
Kitty Adeline Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.2.6.1]
b. 4 Nov 1856
12
Mary Ann Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.2.6.2]
b. 15 Apr 1858 d. 28 Jan 1917 [
=>
]
12
Mary C Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.2.6.3]
b. 10 Jul 1860
11
Mary Elizabeth Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.2.7]
b. 11 Sep 1838 d. 24 Jul 1854
10
Sallie Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.3]
b. 1802
10
Ezra Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.4]
b. 1804 d. 1807
10
Ezra Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.5]
b. 12 Jul 1807 d. 3 Aug 1879
Hannah Maria Jones
b. 1812 d. 2 May 1841
11
John Emory Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.5.1]
b. Feb 1841 d. 30 Dec 1904
Mary Eva Mortimer
b. 7 Oct 1841 d. Aft 1905
12
Francis Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.5.1.1]
b. 6 Jun 1866
12
Agnes Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.5.1.2]
b. 1874
12
Lois Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.5.1.3]
b. Abt 1881
Ann Myatt
b. Abt 1806 d. 12 Mar 1870
11
Mary W Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.5.2]
b. 1844 d. 27 Jun 1917
+
Solomon Wright Davison
b. 1822 d. 21 Oct 1894
+
Catherine Doyle
b. 1843 d. 14 Feb 1886
Lucinda Kingsley
b. 21 Jan 1798 d. 23 Dec 1882
10
Frederick Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.6]
b. 22 Feb 1819 d. 8 Jul 1849
10
William Henry Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.7]
b. 22 Oct 1820 d. 21 Aug 1909
10
Samuel Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.8]
b. 13 Oct 1822 d. 1839
10
Nathaniel Vary Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.9]
b. 13 Oct 1822 d. 15 Feb 1863
Caroline Martin Garr
b. 7 Jul 1836 d. 2 Nov 1912
11
Mark Vary Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.9.1]
b. 3 Jan 1863 d. 1 Mar 1930
Livinia Ann Talbot
b. 10 Nov 1863 d. 2 Sep 1951
12
Nathaniel Vary Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.9.1.1]
b. 24 Jan 1890 d. 15 Mar 1891
12
Clara Lavinia Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.9.1.2]
b. 21 Nov 1891 d. 1 Dec 1968 [
=>
]
12
Olive Myrl Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.9.1.3]
b. 13 Feb 1894 d. 23 Apr 1948 [
=>
]
12
Henry Alvaro Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.9.1.4]
b. 26 Jul 1896 d. 24 Aug 1928
12
Caroline Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.9.1.5]
b. 20 Dec 1896 d. 27 May 1986 [
=>
]
12
Rhoberta Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.9.1.6]
b. 11 Apr 1901 d. 5 Jan 1990 [
=>
]
12
Mark Alloid Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.9.1.7]
b. 27 Jan 1904 d. 31 May 1968 [
=>
]
12
Lois Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.9.1.8]
b. 14 Dec 1906 d. 14 Dec 1906
10
Calvin Kingsley Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.10]
b. 9 Jul 1824 d. 30 Oct 1915
Polly Baxter
b. 11 Oct 1797 d. 6 Jan 1851
10
Isabel Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.11]
b. 16 Jan 1836 d. 6 Mar 1913
Hobart Jones
b. 4 Jun 1832 d. 14 Mar 1887
11
Caroline Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.11.1]
b. 1857 d. 1870
11
William Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.11.2]
b. 1859 d. Bef 1870
11
Alfred Hobart Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.11.3]
b. 14 Nov 1862 d. 28 Aug 1922
Edith Baker
b. 24 Jan 1868 d. 23 Nov 1930
12
Josie Edna Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.11.3.1]
b. 16 Dec 1894 d. 15 Apr 1895
12
Seth Corbit Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.11.3.2]
b. 29 Feb 1896 d. 31 Jul 1956
12
Rueben D Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.11.3.3]
b. 25 Sep 1897 d. 10 Jul 1934
12
Margaret Ann Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.11.3.4]
b. 11 Aug 1902 d. 4 Nov 1975
12
Theodore Roosevelt Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.11.3.5]
b. 19 Oct 1904 d. 11 Dec 1964
12
Cecil Monroe Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.11.3.6]
b. 15 Apr 1906 d. 1 May 1969 [
=>
]
12
Hobart S Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.11.3.7]
b. 10 Jan 1908 d. 6 Jan 1909
11
Mary E Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.11.4]
b. 1867 d. Abt 1897
Rush Carly Kellam
b. 6 Nov 1862 d. 3 Oct 1932
12
Jesse Hobart Kellam
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.11.4.1]
b. 26 Feb 1889 d. 25 Jun 1979 [
=>
]
12
Anna Kellam
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.11.4.2]
b. 1891
12
Lee Kellam
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.11.4.3]
b. 1893
10
Harriet Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.1.12]
b. 2 Apr 1838 d. Aft 1855
9
Aaron Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.2]
b. 23 Mar 1775
9
Sarah Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.3]
b. 23 Sep 1777 d. 17 May 1838
Joel Pratt
b. Abt 1776 d. 18 May 1866
10
Reuben Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.1]
b. 13 Nov 1803 d. 31 May 1861
Mary T
11
Joel F Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.1.1]
b. 27 Sep 1830 d. 1919
Ellen M Doubleday
b. 2 Apr 1835 d. 1913
12
Lizzie E Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.1.1.1]
b. 12 Jun 1869
12
Fannie A Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.1.1.2]
b. 16 Feb 1873
11
Mary Esther Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.1.2]
b. 22 Aug 1834
+
Elbridge H Eames
b. 1825
11
Sarah J Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.1.3]
b. 1837
11
Jacob Elbridge Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.1.4]
b. 12 Dec 1838
11
Nelson Reuben Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.1.5]
b. Abt 1841 d. 31 Mar 1895
Anna Lostin Withee
b. Abt 1844 d. 24 Jan 1905
12
Eva Leah Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.1.5.1]
b. Dec 1863 [
=>
]
12
Samuel T Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.1.5.2]
b. 1867 [
=>
]
12
Lizzie M Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.1.5.3]
b. 13 Mar 1875 d. 24 Jun 1889
11
Marilla Sarah Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.1.6]
b. 1844
Olive Fitzgerald
b. 13 Jun 1816
11
Henrietta F. Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.1.7]
b. 1850 d. 19 Feb 1934
10
Nelson Chapin Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.2]
b. 18 Jul 1805 d. 14 Mar 1864
Artemesia Hammond
b. 5 May 1809
11
Sarah Jones Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.2.1]
b. 13 May 1828 d. 14 Dec 1862
Daniel Webster Smith
b. 18 Apr 1826 d. 16 Dec 1888
12
Clara Luella Smith
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.2.1.1]
b. 26 Mar 1849
12
Isaac Smith
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.2.1.2]
b. 9 Dec 1850 d. 19 Mar 1918 [
=>
]
12
Daniel Webster Smith
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.2.1.3]
b. 16 Feb 1853 d. 18 Jan 1918
12
Edward Crawford Smith
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.2.1.4]
b. 24 Aug 1855 d. 16 Jun 1864
12
Elizabeth Smith
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.2.1.5]
b. 15 Nov 1857 d. 8 Oct 1893 [
=>
]
12
Charles Hammond Smith
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.2.1.6]
b. 9 Apr 1860
11
Martha Baker Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.2.2]
b. 7 Nov 1830
11
Maria Hammond Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.2.3]
b. Abt 1834 d. 28 Dec 1863
11
Artimisha Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.2.4]
b. Abt 1835
Julia Abbie Gowen
b. Abt 1818 d. 9 Oct 1886
11
George Oscar Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.2.5]
b. 4 Apr 1845 d. 1 May 1929
Alice E Taylor
b. 5 May 1849 d. 4 Dec 1926
12
Albert Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.2.5.1]
b. 1869
12
Fred Elmer Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.2.5.2]
b. 25 Apr 1872 d. 26 Aug 1949
12
Ivy Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.2.5.3]
b. Abt 1874
12
William Andrus Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.2.5.4]
b. 27 Jan 1879
12
Charles Francis Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.2.5.5]
b. Abt 1882
12
George Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.2.5.6]
b. Abt 1885
12
Robert Fulton Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.2.5.7]
b. 30 Jun 1887
11
Francis A Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.2.6]
b. Apr 1847 d. 1945
Mary Elizabeth Libby
b. Abt 1847 d. 1934
12
Isa R Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.2.6.1]
b. May 1870 d. 1960
12
Anna B Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.2.6.2]
b. May 1872
12
Sadie M Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.2.6.3]
b. Abt 1875
12
Bertha E Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.2.6.4]
b. 21 May 1879
12
Frank Adelbert Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.2.6.5]
b. 21 May 1879 d. 15 Jul 1966
12
Luella L Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.2.6.6]
b. Mar 1881
12
Ruth Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.2.6.7]
b. 1883
11
William A Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.2.7]
b. Abt 1850
11
Nelson Chapman Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.2.8]
b. 31 Oct 1851 d. 1912
Sarah Narcissa McFarland
b. 31 Oct 1867 d. 1936
12
Pearl Auntie Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.2.8.1]
b. Dec 1889
12
Mayme Gertrude Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.2.8.2]
b. 8 Nov 1896 d. 24 Dec 1983 [
=>
]
11
Lillie Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.2.9]
b. Abt 1854
10
Seth Corbett Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.3]
b. 2 Sep 1807 d. 2 Jun 1880
Mary Herring
b. 2 Feb 1813 d. 22 Nov 1895
11
Cyntha B Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.3.1]
b. 21 Mar 1835 d. 28 May 1928
George Dana Boardman Herring
b. 25 Feb 1834 d. 17 Dec 1898
12
Fred Herbert Herring
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.3.1.1]
b. 31 Mar 1858 d. 1 Aug 1919
12
Charles Henry Herring
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.3.1.2]
b. 24 Jul 1859 d. 10 Jan 1862
12
John H. Herring
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.3.1.3]
b. 5 Jul 1861 d. 3 Apr 1862
12
Freeland W Herring
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.3.1.4]
b. 3 Jun 1868 d. 1948
11
Henry Otis Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.3.2]
b. 11 Feb 1838 d. 22 May 1901
Hala Woodard
b. 18 Apr 1844 d. 9 Apr 1931
12
Myrtilia Hala Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.3.2.1]
b. 20 Sep 1866
12
Gertrude Emma Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.3.2.2]
b. 29 May 1868
12
George H Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.3.2.3]
b. 22 Mar 1871 d. 23 Oct 1893
12
Henry Otis Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.3.2.4]
b. 26 Jul 1872 d. 28 Feb 1903
12
Ralph Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.3.2.5]
b. 2 Jun 1875 d. 3 Apr 1899
12
Ruth Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.3.2.6]
b. 6 May 1883
11
George William Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.3.3]
b. 13 Aug 1840 d. 18 Apr 1910
+
Elmira Frances Stickney
b. 18 May 1841
Margaret Yeoman
b. 18 Mar 1865
12
Lillian Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.3.3.1]
b. 1888 d. 1889
12
George Henry Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.3.3.2]
b. 4 Jan 1895
11
Emilie H Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.3.4]
b. 16 Dec 1849
+
Henry B Stanhope
b. 5 Jan 1844
10
Lawson Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.4]
b. 13 Sep 1810
Caroline
b. 1814
11
Eugene Abba Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.4.1]
b. 14 Jul 1837
10
Esther Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.5]
b. 12 Dec 1812
Daniel Mansfield
b. 20 Dec 1808
11
Joseph D Mansfield
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.5.1]
b. 1842
11
Stacy Tucker Mansfield
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.5.2]
b. 19 May 1845
Mary Ellen Loud
b. 14 Mar 1854
12
Ethel Mary Mansfield
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.5.2.1]
b. 10 Jun 1877 d. 1972
12
Avis Loud Mansfield
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.5.2.2]
b. 10 Apr 1880
11
Julia L Mansfield
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.5.3]
b. 1846 d. 20 Apr 1894
+
Benjamin Franklin Pratt
b. 18 Jan 1839 d. 16 Jul 1912
11
Seth C P Mansfield
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.5.4]
b. 1848
11
Sarah A Mansfield
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.5.5]
b. 1850
11
Wooster P Mansfield
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.5.6]
b. 1852
Maria J Bolton
b. Jul 1850
12
Bertha Eliza Mansfield
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.5.6.1]
b. 27 Jun 1882
11
Charles O Mansfield
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.5.7]
b. 1855
10
Marilla May Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.6]
b. 3 Sep 1814 d. 4 Mar 1835
10
Joel Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.7]
b. 3 Sep 1817 d. 1822
10
Sarah Jane Pratt
[1.3.1.1.1.4.2.2.3.8]
b. 30 Aug 1819 d. 12 May 1838
9
Mary Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.4]
b. 9 Dec 1780 d. 30 Oct 1831
John Bigelow
b. 12 Aug 1787 d. 6 Sep 1808
10
Mary Dagget Bigelow
[1.3.1.1.1.4.2.2.4.1]
b. 4 Apr 1807 d. 6 Mar 1873
Varnum Brigham
b. 8 Jul 1802 d. 25 Jul 1848
11
Persis Penelope Brigham
[1.3.1.1.1.4.2.2.4.1.1]
b. 1 Aug 1825 d. 4 Jan 1851
11
Mary Jones Brigham
[1.3.1.1.1.4.2.2.4.1.2]
b. 14 Jun 1827 d. 25 Sep 1827
11
Calvin L Brigham
[1.3.1.1.1.4.2.2.4.1.3]
b. 8 Sep 1828 d. 15 Oct 1850
11
Sarah J Brigham
[1.3.1.1.1.4.2.2.4.1.4]
b. 23 Sep 1830 d. 23 Jan 1856
+
William Eager
b. Abt 1826 d. Abt 1886
11
Varnum Bigelow Brigham
[1.3.1.1.1.4.2.2.4.1.5]
b. 21 Feb 1833 d. Abt 1893
Cate Harris
b. Abt 1837 d. Abt 1897
12
Varnum Charles Brigham
[1.3.1.1.1.4.2.2.4.1.5.1]
b. Abt 1859
11
Emery P Brigham
[1.3.1.1.1.4.2.2.4.1.6]
b. 18 Jan 1835 d. Jan 1835
11
Mary Lucy Brigham
[1.3.1.1.1.4.2.2.4.1.7]
b. 18 May 1836 d. 1872
John H Robinson
b. 1832 d. Abt 1892
12
Willie H Robinson
[1.3.1.1.1.4.2.2.4.1.7.1]
b. Abt 1858
11
Frances Felicia Brigham
[1.3.1.1.1.4.2.2.4.1.8]
b. 3 Sep 1838 d. 24 May 1900
Nathaniel Fenner Hopkins
b. 4 Feb 1838 d. Abt 1898
12
Clarence B Hopkins
[1.3.1.1.1.4.2.2.4.1.8.1]
b. 4 Jul 1862
12
Martha Amelia Hopkins
[1.3.1.1.1.4.2.2.4.1.8.2]
b. 18 Feb 1865
12
Maude Frances Hopkins
[1.3.1.1.1.4.2.2.4.1.8.3]
b. 30 Mar 1867
12
Florence Evelyn Hopkins
[1.3.1.1.1.4.2.2.4.1.8.4]
b. 1 Oct 1868
12
Stella Hopkins
[1.3.1.1.1.4.2.2.4.1.8.5]
b. 17 Jun 1870
11
Martha A Brigham
[1.3.1.1.1.4.2.2.4.1.9]
b. 25 Jul 1840 d. 1864
+
George Shattuck
b. 1836 d. Abt 1896
11
John A Brigham
[1.3.1.1.1.4.2.2.4.1.10]
b. 18 Sep 1843 d. 2 Aug 1854
11
Abby H Brigham
[1.3.1.1.1.4.2.2.4.1.11]
b. 31 Dec 1845 d. Abt 1905
Horace M Emerson
b. 7 Nov 1840 d. 1881
12
Mary D Emerson
[1.3.1.1.1.4.2.2.4.1.11.1]
b. 1866
12
Oliver Emerson
[1.3.1.1.1.4.2.2.4.1.11.2]
b. 1869
10
John Jones Bigelow
[1.3.1.1.1.4.2.2.4.2]
b. 31 Jan 1809 d. 2 Jun 1848
Susan McKinstry
b. 1 Jun 1816 d. 8 Nov 1891
11
John Karresty Bigelow
[1.3.1.1.1.4.2.2.4.2.1]
b. 7 Aug 1836 d. 21 Aug 1836
11
Andrew Laroy Bigelow
[1.3.1.1.1.4.2.2.4.2.2]
b. 16 Aug 1840
Mary Theresa Higgins
b. 22 May 1846
12
Justin Osbert Bigelow
[1.3.1.1.1.4.2.2.4.2.2.1]
b. 6 Jul 1868
12
Mary Elizabeth Bigelow
[1.3.1.1.1.4.2.2.4.2.2.2]
b. 9 Aug 1869
12
Harry Laroy Bigelow
[1.3.1.1.1.4.2.2.4.2.2.3]
b. 7 Nov 1870
9
Lydia Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.5]
b. 15 Oct 1783
9
Seth Corbett Jones, Jr
[1.3.1.1.1.4.2.2.6]
b. 16 Oct 1785 d. 27 May 1807
9
Altheda Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.7]
b. 27 Oct 1787 d. 28 Mar 1790
9
Cynthia Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.8]
b. 13 May 1791 d. 5 Jan 1827
9
Rachel Jones
[1.3.1.1.1.4.2.2.9]
b. 23 Apr 1793 d. 3 May 1823
8
David Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.3]
b. 27 Jun 1751 d. 14 May 1777
Bulah Johnson
b. 1750
9
Azubah Dagget
[1.3.1.1.1.4.2.3.1]
b. 15 Mar 1774
Daniel Town
b. 1774
10
Betsy Town
[1.3.1.1.1.4.2.3.1.1]
b. 1795 d. 13 Feb 1890
Abegence Weld
b. 12 Mar 1795 d. 5 Nov 1848
11
William Weld
[1.3.1.1.1.4.2.3.1.1.1]
b. 1817
Sarah E Weld
b. 1820
12
Frank Russell Weld
[1.3.1.1.1.4.2.3.1.1.1.1]
b. 24 May 1854
11
Damon Weld
[1.3.1.1.1.4.2.3.1.1.2]
b. 1820 d. 6 Jun 1847
11
Deborah Weld
[1.3.1.1.1.4.2.3.1.1.3]
b. 1822
11
Russell Weld
[1.3.1.1.1.4.2.3.1.1.4]
b. 18 Jun 1824 d. 5 May 1904
+
Content H Porter
b. 1828 d. 5 May 1904
11
Philena Weld
[1.3.1.1.1.4.2.3.1.1.5]
b. 1828 d. 9 Jun 1898
Thomas Miles Dwelly
b. 12 Jul 1822 d. 21 Jan 1885
12
Lena Dwelly
[1.3.1.1.1.4.2.3.1.1.5.1]
b. 30 Jun 1878
11
Adaline Elizabeth Weld
[1.3.1.1.1.4.2.3.1.1.6]
b. Abt 1833 d. 2 Jan 1914
David Clinton Bradway
b. 14 Nov 1831 d. 20 Oct 1914
12
Abby Josephine Bradway
[1.3.1.1.1.4.2.3.1.1.6.1]
b. 18 Nov 1855 d. 5 Jan 1856
12
Herbert Clinton Bradway
[1.3.1.1.1.4.2.3.1.1.6.2]
b. 5 May 1857 d. 19 Aug 1937 [
=>
]
12
William Weld Bradway
[1.3.1.1.1.4.2.3.1.1.6.3]
b. 14 Mar 1863 d. 5 Feb 1936 [
=>
]
12
Bessie Bradway
[1.3.1.1.1.4.2.3.1.1.6.4]
b. 1865 d. 1866
11
Daniel Weld
[1.3.1.1.1.4.2.3.1.1.7]
b. 1834 d. 9 Dec 1899
Eliza Holmes
b. Sep 1839 d. 1 Apr 1921
12
Etta L Weld
[1.3.1.1.1.4.2.3.1.1.7.1]
b. Jan 1859 d. 31 Oct 1936 [
=>
]
12
Cora Bell Weld
[1.3.1.1.1.4.2.3.1.1.7.2]
b. 1867 d. 21 Aug 1867
12
Bessie Weld
[1.3.1.1.1.4.2.3.1.1.7.3]
b. Jul 1869 d. 9 Dec 1954
Azubah Wheelock
b. 15 Jan 1745 d. 8 Feb 1804
9
Lyman Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.3.2]
b. 22 Aug 1775 d. 30 Apr 1870
Sarah West Hathaway
b. 22 Feb 1785
10
Catherine H Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.3.2.1]
b. 27 Aug 1807 d. 19 Jan 1890
Loam Hathaway
b. 15 Sep 1803 d. 26 Sep 1883
11
Edwin Augustus Hathaway
[1.3.1.1.1.4.2.3.2.1.1]
b. 1 Feb 1831 d. 29 Mar 1835
11
Martin Van Buren Hathaway
[1.3.1.1.1.4.2.3.2.1.2]
b. 21 Sep 1837 d. 3 Jan 1894
+
Eliza Marie Noyes
b. 28 Jul 1854 d. 12 Jan 1936
11
Fernando Cortez Hathaway
[1.3.1.1.1.4.2.3.2.1.3]
b. 29 Aug 1844 d. 6 Jul 1873
Hattie Z Woodbury
b. 22 Jun 1846
12
Son Hathaway
[1.3.1.1.1.4.2.3.2.1.3.1]
b. 31 Jul 1870
12
Alice Corey Hathaway
[1.3.1.1.1.4.2.3.2.1.3.2]
b. 18 Apr 1873
11
Lyman Daggett Hathaway
[1.3.1.1.1.4.2.3.2.1.4]
b. 29 Aug 1833 d. 27 May 1890
Selina E Drew
b. 8 Aug 1834
12
Ina Estella Hathaway
[1.3.1.1.1.4.2.3.2.1.4.1]
b. 3 Feb 1877
10
Clarissa Amanda Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.3.2.2]
b. 22 Oct 1810 d. 7 Jan 1879
Chester Bugbee
b. 21 Sep 1808 d. 22 May 1875
11
Walter S Bugbee
[1.3.1.1.1.4.2.3.2.2.1]
b. 20 Mar 1818 d. 1 Apr 1825
11
Sarah West Bugbee
[1.3.1.1.1.4.2.3.2.2.2]
b. 4 Jan 1835
+
George S Gray
b. 16 Jan 1834
11
Willard Chester Bugbee
[1.3.1.1.1.4.2.3.2.2.3]
b. 19 Jul 1836 d. 11 Jun 1918
Laura Amanda Hammond
b. 4 Nov 1842 d. 18 Jan 1864
12
Mary A Bugbee
[1.3.1.1.1.4.2.3.2.2.3.1]
b. 4 Apr 1861 d. 25 Dec 1863
12
Minnie G Bugbee
[1.3.1.1.1.4.2.3.2.2.3.2]
b. 17 May 1863 [
=>
]
Emma A Paine
b. 25 Oct 1845
12
Chester Willard Bugbee
[1.3.1.1.1.4.2.3.2.2.3.3]
b. 3 Aug 1870 d. 1920 [
=>
]
12
Katie Stevens Bugbee
[1.3.1.1.1.4.2.3.2.2.3.4]
b. 2 Jul 1871 [
=>
]
12
Angie E Bugbee
[1.3.1.1.1.4.2.3.2.2.3.5]
b. 9 Nov 1878 d. 12 Apr 1896
12
Frank A Bugbee
[1.3.1.1.1.4.2.3.2.2.3.6]
b. 8 Apr 1885
11
Julia Amanda Bugbee
[1.3.1.1.1.4.2.3.2.2.4]
b. 19 Aug 1838 d. 9 Aug 1863
+
Edward Morris Hamblett
b. 13 Mar 1829 d. 12 Apr 1893
11
Catherine Reliance Bugbee
[1.3.1.1.1.4.2.3.2.2.5]
b. 11 Feb 1841
Clark M Gray
b. 27 Jun 1842
12
Daughter Gray
[1.3.1.1.1.4.2.3.2.2.5.1]
b. 19 Jul 1872
11
Maria E Bugbee
[1.3.1.1.1.4.2.3.2.2.6]
b. 6 Apr 1843
Elias Benjamin Wakefield
b. 29 Jan 1844
12
Anna M Wakefield
[1.3.1.1.1.4.2.3.2.2.6.1]
b. 17 Nov 1868
12
Mary Alice Wakefield
[1.3.1.1.1.4.2.3.2.2.6.2]
b. 20 Feb 1871
12
Charles Elmore Wakefield
[1.3.1.1.1.4.2.3.2.2.6.3]
b. 13 Dec 1882
11
William Wallace Bugbee
[1.3.1.1.1.4.2.3.2.2.7]
b. 5 Apr 1845 d. 22 Aug 1846
11
Walter S Bugbee
[1.3.1.1.1.4.2.3.2.2.8]
b. 3 Mar 1848 d. 7 Jul 1863
11
Emma Arvilla Bugbee
[1.3.1.1.1.4.2.3.2.2.9]
b. 19 Jan 1849 d. 25 May 1881
Edward Morris Hamblett
b. 13 Mar 1829 d. 12 Apr 1893
12
Della Julia Hamblet
[1.3.1.1.1.4.2.3.2.2.9.1]
b. 25 Mar 1863 d. 1 Oct 1916 [
=>
]
12
Lunn Lorenzo Hamblett
[1.3.1.1.1.4.2.3.2.2.9.2]
b. 25 Feb 1876 d. 26 Mar 1959 [
=>
]
10
Pardon Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.3.2.3]
b. 14 Feb 1818 d. 1 Apr 1825
9
David Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.3.3]
b. 31 Jan 1776 d. 28 Sep 1861
Hannah Moffett
b. 7 Jan 1776 d. 31 Jan 1810
10
Sally Learned Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.1]
b. 13 Apr 1799 d. Bef 1834
+
Thomas Pray
b. 1801 d. 12 Jan 1876
10
Azubah Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.2]
b. 8 Mar 1802 d. 3 May 1881
Jonathan Danforth
b. 11 May 1798 d. 23 Feb 1859
11
Philora A Danforth
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.2.1]
b. 1828 d. 15 Mar 1857
11
Augusta Danforth
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.2.2]
b. 1831 d. Aft 1850
11
Cynthia Danforth
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.2.3]
b. 1833 d. Aft 1850
11
Emily J Danforth
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.2.4]
b. 1834 d. 21 Aug 1853
11
Chancy B Danforth
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.2.5]
b. 1835 d. 19 May 1860
11
Helen M Danforth
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.2.6]
b. 1837 d. 17 Jan 1861
11
Sarah Jane Danforth
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.2.7]
b. 1839 d. Aft 1850
11
Harriet N Danforth
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.2.8]
b. 1842 d. 5 May 1862
10
Erasmus Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.3]
b. 13 Mar 1804
10
Asahel Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.4]
b. 15 Feb 1807 d. 13 Mar 1890
Eliza White
b. 15 Sep 1810 d. Mar 1861
11
Delia Ann Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.4.1]
b. May 1830 d. May 1861
11
William Penn Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.4.2]
b. 1834
Elizabeth "Betsey" Shepherd
b. 9 Sep 1838 d. 30 May 1928
12
John Welsley Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.4.2.1]
b. Jun 1858 [
=>
]
11
Caroline Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.4.3]
b. 1849
Henry Sanford Gideon
b. 1 Sep 1836 d. 28 Dec 1902
12
Jene Gideon
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.4.3.1]
b. 1862
12
John Gideon
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.4.3.2]
b. 1869
12
Edith Gideon
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.4.3.3]
b. 1871
12
Elizabeth Gideon
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.4.3.4]
b. 1873
12
William Henry Gideon
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.4.3.5]
b. 10 Feb 1877 d. 22 Jul 1943 [
=>
]
12
Ada M Gideon
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.4.3.6]
b. 1879
12
Zea Asheal Gideon
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.4.3.7]
b. 20 Sep 1881 [
=>
]
12
Herman Sanford "Dick" Gideon
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.4.3.8]
b. 11 Apr 1885 d. 3 Feb 1975 [
=>
]
12
Bessie May Gideon
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.4.3.9]
b. 1886
10
Rheuphemia Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.5]
b. 19 Oct 1809
Elizabeth Tobey
b. 22 Nov 1791 d. 1862
10
Eli Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.6]
b. 7 Feb 1815 d. Abt 1815
10
Polly W Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.7]
b. 25 Feb 1818
10
Maria Keziah Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.8]
b. 20 Apr 1820 d. 2 Dec 1883
Thomas B Muldoon
b. 1820 d. 21 Apr 1870
11
James D Muldoon
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.8.1]
b. Jun 1847 d. 28 Dec 1906
Susan E Ismon
b. Feb 1853
12
Kate Muldoon
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.8.1.1]
b. Abt 1876 d. Aft 1895
12
Henry James Muldoon
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.8.1.2]
b. 20 Jun 1878 d. Aft 1895
12
Kenneth Thomas Muldoon
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.8.1.3]
b. 26 Sep 1883 d. Aft 1895
11
Frank M Muldoon
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.8.2]
b. Dec 1849
11
Clara Muldoon
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.8.3]
b. Abt 1855 d. 1883
11
Frederick B Muldoon
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.8.4]
b. 1858 d. 20 Feb 1888
11
Emma M Muldoon
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.8.5]
b. 1863 d. 1940
10
Lyman Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.9]
b. 22 Feb 1822 d. 26 Mar 1902
Mary E Belding
b. 1829 d. Bef 1900
11
Arthur B Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.9.1]
b. 1856 d. Aft 1910
Madge Clark
b. Feb 1875 d. Aft 1915
12
Clark Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.9.1.1]
b. Abt 1902 d. Aft 1915
12
Lenore Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.9.1.2]
b. Abt 1908 d. Aft 1915
11
Freeman L Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.9.2]
b. 1858 d. 14 Feb 1935
Edith E Doran
b. Sep 1868 d. Aft 1900
12
John D Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.9.2.1]
b. Dec 1897 d. Aft 1900
11
Bertha E Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.9.3]
b. Jul 1864 d. Aft 1900
10
Avery Tobey Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.10]
b. 16 Dec 1824 d. Aft 1880
Mary S
b. Apr 1848 d. Aft 1905
11
William Lee Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.10.1]
b. Jul 1869 d. Aft 1905
+
Lilly Lucretia Hale
b. 1867 d. Aft 1905
10
David Janson Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.11]
b. 4 May 1827 d. 30 Dec 1894
Katherine Roddy
b. Abt 1844 d. 13 Jul 1900
11
Abner Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.11.1]
b. 1861 d. Aft 1885
11
Fred E Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.11.2]
b. 23 Aug 1864 d. 7 Nov 1907
11
Eldridge Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.11.3]
b. Mar 1865 d. 1927
+
Isabella M Gardiner
b. Nov 1872 d. Aft 1905
11
Edward R Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.11.4]
b. 1868 d. 21 Mar 1927
11
Frank M Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.11.5]
b. 21 Jun 1872 d. 18 Jul 1922
Edith Price
b. 1876
12
William Rod Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.11.5.1]
b. 31 May 1896 d. 23 Feb 1979
11
Katheryn Carrie Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.11.6]
b. 11 Sep 1878 d. 22 Jun 1958
+
Edward L Tate
b. Abt 1858 d. 3 Jan 1930
10
Cordelia Flavilla Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.12]
b. 3 Feb 1831 d. Aft 1900
John R Cooley
b. 1832 d. Bef 1900
11
Ella Cooley
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.12.1]
b. 1869 d. Bef 1900
10
Elizabeth Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.3.3.13]
b. Dec 1833
8
Hannah Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.4]
b. 23 Dec 1753
8
Martha Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.5]
b. 2 Jun 1755
Edward Wheelock
b. 1754
9
Relief Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.1]
b. 2 Sep 1777
9
Silas Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2]
b. 20 Apr 1781 d. 30 Oct 1851
Rena Baldwin
b. 26 Feb 1778 d. 28 Jun 1833
10
Lewis Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.1]
b. 5 Dec 1807 d. 24 Dec 1881
Eliza Palmer
b. Abt 1813
11
Clarinda Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.1.1]
b. Abt 1832
11
Albert H Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.1.2]
b. Abt 1833 d. Aft 1912
+
Emily Hubbard
b. 1834 bur. 23 Sep 1873
11
Orlando Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.1.3]
b. 30 Jul 1834 d. 7 Nov 1900
Susan Foote
b. 14 Nov 1839
12
Flora Belle Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.1.3.1]
b. 22 Feb 1867 [
=>
]
11
Mary Ann Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.1.4]
b. 11 Aug 1835 d. Abt 1874
Daniel Chase
b. 24 Aug 1834 d. 28 Jan 1902
12
Estella Chase
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.1.4.1]
b. 22 Jan 1861 [
=>
]
12
Elmer C Chase
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.1.4.2]
b. 28 Dec 1865
12
Velma Chase
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.1.4.3]
b. 16 Jan 1873
11
Lewis M Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.1.5]
b. Abt 1837
11
Almina Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.1.6]
b. Abt 1838
11
Fred Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.1.7]
b. Abt 1840
11
Irena Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.1.8]
b. Abt 1842
11
Cyrus Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.1.9]
b. Abt 1843
11
Phebe Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.1.10]
b. Abt 1845
10
Olive Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.2]
b. 9 Apr 1806
10
Albert Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.3]
b. 3 Jan 1805 d. 8 Jun 1875
Lisena Clark
b. 4 Jan 1811 d. 25 Jan 1894
11
Laura Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.3.1]
b. Abt 1831
11
Mariette Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.3.2]
b. Abt 1835
11
William H Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.3.3]
b. Abt 1837
11
Oscar F Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.3.4]
b. Abt 1841
Nancy
b. Abt 1845
12
Hattie Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.3.4.1]
b. Abt 1871
12
Arthur Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.3.4.2]
b. Abt 1873
12
Fred Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.3.4.3]
b. Abt 1875
12
Matie Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.3.4.4]
b. Abt 1877
10
Scinda Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.4]
b. 16 Sep 1809 d. 14 Oct 1845
+
Michael Hutchinson
10
Silas B Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.5]
b. 6 Jun 1811 d. 16 Nov 1897
Phebe Smith
b. 26 Nov 1809 d. 8 Jul 1890
11
Julia Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.5.1]
b. 7 Jan 1836 d. 19 Jan 1865
11
Jane Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.5.2]
b. 7 Jul 1838 d. 3 May 1882
+
Horace W White
d. 28 Feb 1896
11
Martha S Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.5.3]
b. 22 Sep 1840 d. 14 Nov 1899
+
Charles W Bourne
b. 1838 d. 1925
11
Hilton Haven Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.5.4]
b. 2 Apr 1843 d. 7 Oct 1925
+
Martha L Merrice
b. 1848 d. Nov 1865
Orpha Sophia Fritts
b. 4 Apr 1843 d. 27 Aug 1915
12
Frank H Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.5.4.1]
b. 3 Jan 1870 d. Jan 1946
12
Clara Josephine Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.5.4.2]
b. 13 Oct 1874 d. 14 Jan 1965
12
Alton R Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.5.4.3]
b. 27 Feb 1880 d. 1 Apr 1964 [
=>
]
10
John Homer Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.6]
b. 26 May 1813 d. 28 Mar 1887
Sarah L Houghton
b. 29 Apr 1816 d. 16 Nov 1890
11
Amelia Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.6.1]
b. 1843 d. 1925
M Lafayette Ranlett
b. 1838 d. 1925
12
Ida Ranlett
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.6.1.1]
12
Lois Ranlett
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.6.1.2]
12
William H Ranlett
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.6.1.3]
b. 14 Oct 1878 d. 8 Aug 1950 [
=>
]
11
Theodore Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.6.2]
b. 5 May 1844 d. 31 Dec 1898
Clarabelle Miller
b. 3 May 1851 d. 12 Nov 1904
12
William Homer Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.6.2.1]
b. 15 Oct 1886 d. 19 Oct 1975
11
Agustus J Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.6.3]
b. 29 Dec 1848
11
Augusta Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.6.4]
b. 29 Dec 1848 d. 1900
11
Zenas Elmer Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.6.5]
b. 14 Apr 1849 d. 14 Feb 1926
+
Emma L Tanner
b. 5 Jan 1857 d. 22 Aug 1890
11
Delia Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.6.6]
b. 18 Aug 1853 d. 4 Apr 1914
11
Delitah Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.6.7]
b. 18 Aug 1853 d. 1934
10
Harmon Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.7]
b. 13 Mar 1815 d. 1892
+
Amanda S Hill
b. Abt 1807 d. 27 Dec 1893
10
Nancy B Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.8]
b. 17 Sep 1817 d. 20 Dec 1842
10
Joseph S Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.9]
b. 1 Nov 1819 d. 21 Apr 1902
Paula Almira Crandall
b. 19 Sep 1826 d. 1899
11
Silas Stanton Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.9.1]
b. 30 Jun 1851 d. 25 Feb 1931
Nettie Marilla Crumb
b. 3 Aug 1855 d. 8 Nov 1950
12
Edith May Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.9.1.1]
b. 18 May 1883 d. 21 Oct 1956 [
=>
]
12
Genevieve Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.9.1.2]
b. 13 Nov 1888 [
=>
]
12
Bertha Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.9.1.3]
b. 28 Aug 1890
12
Delia Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.9.1.4]
b. 4 Nov 1893 d. 21 Feb 1981
11
Mary J Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.9.2]
b. 22 Nov 1852 d. 28 Sep 1870
11
Florence Ann Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.9.3]
b. 7 Jun 1854 d. May 1916
Edgar Jay
b. 3 Feb 1844 d. 14 May 1914
12
Floyd H Jay
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.9.3.1]
b. 6 May 1876 d. 6 Oct 1965
12
Girdon E Jay
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.9.3.2]
b. 5 Jul 1878
11
Millard Fillmore Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.9.4]
b. 27 Aug 1856 d. 15 Feb 1931
Persis Ellen Lewis
b. 18 Dec 1861 d. 20 Jan 1900
12
Dime H Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.9.4.1]
b. 1 Oct 1884 d. 6 Jul 1961
12
Maurice J Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.9.4.2]
b. 26 Nov 1886 d. 6 Dec 1975
12
Julia Nell Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.9.4.3]
b. 25 Mar 1889 d. 13 Nov 1941 [
=>
]
12
Ellis Harold Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.9.4.4]
b. 29 Apr 1891 d. 14 Feb 1963 [
=>
]
12
Doris Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.9.4.5]
b. 5 Mar 1899 d. 19 Sep 1962
11
Lillian Victoria Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.9.5]
b. 29 Jul 1858 d. 1 Oct 1907
Phiny Shattuck
b. 21 Jun 1863 d. 24 Jan 1919
12
Charles L Shattuck
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.9.5.1]
b. 24 Nov 1889 d. 29 Oct 1956
12
Elmer B Shattuck
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.9.5.2]
b. 9 Oct 1893 d. 13 Feb 1976
10
Zenas S Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.10]
b. 29 Aug 1821 d. 25 May 1844
10
James Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.11]
b. 4 Jul 1824
10
Sophronia Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.2.12]
b. 25 Oct 1826
+
George Smith
+
Sarah Hurlbut
b. 21 Mar 1790 d. 1855
9
Lynda Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.3]
b. 15 Apr 1783
9
Reuben Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.4]
b. 23 Jul 1785 d. 29 Jul 1833
Rosanna Smiley
b. 5 Jun 1783 d. 30 Apr 1874
10
Agusta Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.1]
b. Abt 1806
10
Gillman Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.2]
b. Abt 1808
10
Sarah Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.3]
b. Abt 1810
10
Eliza Ann Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.4]
b. Abt 1812
10
Laurane Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.5]
b. 1 Sep 1814 d. 24 Mar 1884
Frederick S Benham
b. 2 Jan 1811 d. 21 Jul 1861
11
Mary Eliza Benham
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.5.1]
b. 1835 d. 31 Aug 1873
Benjamin V Ensley
b. 16 Apr 1830 d. 12 Dec 1889
12
Marie E Ensley
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.5.1.1]
b. 1856
12
William B Ensley
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.5.1.2]
b. 1858 d. 1903 [
=>
]
12
Eliza A Ensley
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.5.1.3]
b. Dec 1859
12
Benjamin F Ensley
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.5.1.4]
b. Dec 1861 [
=>
]
12
Frank D Ensley
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.5.1.5]
b. 24 Apr 1865 d. Apr 1866
12
Antoinette Ensley
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.5.1.6]
b. 2 Jul 1867 d. 1918 [
=>
]
12
Laurane Ensley
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.5.1.7]
b. 8 Jun 1868
12
John Ensley
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.5.1.8]
b. 31 Aug 1873 d. Sep 1873
11
Fernando Benham
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.5.2]
b. 15 Nov 1836 d. 7 Feb 1900
Malony Malora Parkinson
b. 17 Jun 1844 d. 1927
12
Addie Adell Benham
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.5.2.1]
b. 23 Feb 1864 d. 16 Nov 1943 [
=>
]
12
Samuel H Benham
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.5.2.2]
b. 21 Feb 1866 d. 31 Mar 1911 [
=>
]
12
James F Benham
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.5.2.3]
b. 3 Mar 1868
12
Clinton G Benham
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.5.2.4]
b. Dec 1870 d. 9 Apr 1923 [
=>
]
12
Frank W Benham
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.5.2.5]
b. 13 Apr 1871
11
Maria A Benham
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.5.3]
b. 1838 d. 1854
11
James Louis Benham
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.5.4]
b. 1841 d. 1861
11
Elizabeth Benham
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.5.5]
b. 1843
11
Frederick S Benham, Jr
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.5.6]
b. 1846
11
Francis M Benham
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.5.7]
b. 1849 d. 1915
11
Charles W Benham
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.5.8]
b. 1853 d. 1900
10
Emmons Howe Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.6]
b. 17 May 1817 d. 27 Apr 1899
Polly Wilson
b. Abt 1824 d. 6 Dec 1904
11
Mary Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.6.1]
b. 19 Jan 1848
11
George Washington Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.6.2]
b. 25 Dec 1849 d. 21 Jan 1935
Grace Amelia O'dell
12
Clifford Judson Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.6.2.1]
b. 6 Jun 1879 d. 1943
12
Charles Emmons Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.6.2.2]
b. 1 Jan 1881 d. 21 Oct 1966
12
Frank Seldon Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.6.2.3]
b. 16 Apr 1883 d. 1942
12
Glanis Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.6.2.4]
b. 5 Sep 1885
12
Glenn E Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.6.2.5]
b. 6 Sep 1886 d. 1975
12
Fern Lenora Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.6.2.6]
b. 1 Mar 1891 d. 4 Oct 1976
12
Herbert Lee Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.6.2.7]
b. 10 Aug 1894
11
Warren J Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.6.3]
b. 16 Mar 1851 d. 23 Feb 1934
Florence Amanda Haynes
b. 21 Mar 1854 d. 10 Dec 1929
12
Blanche Jane Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.6.3.1]
b. 8 Oct 1885 d. 24 Apr 1944 [
=>
]
11
Marion Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.6.4]
b. 12 Aug 1852 d. 19 Mar 1926
11
Eliza Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.6.5]
b. 26 Apr 1855 d. 21 Apr 1934
11
Martin Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.6.6]
b. 18 Jul 1856 d. 19 Oct 1923
11
Arthur Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.6.7]
b. 7 Mar 1858 d. 29 Dec 1937
11
Selden Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.6.8]
b. 24 Dec 1859 d. 9 Oct 1933
Nancy Bond
b. Apr 1869
12
Donald J Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.6.8.1]
b. 1911 d. 2006
11
Amos Solon Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.6.9]
b. Abt 1861 d. 1887
11
Olive L Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.6.10]
b. 25 Apr 1868 d. 10 Oct 1932
+
Emanuel H Koch
11
Ada Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.6.11]
b. Abt 1870
10
Caroline Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.7]
b. 29 Sep 1819
10
Andrew Jackson Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.8]
b. 1 Jun 1822 d. 31 May 1915
Mary Ann Gregory
b. 1 Jul 1826
11
Leah Josephine Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.8.1]
b. 14 Dec 1849
Bridget Mary Evans
b. 27 Dec 1826 d. 4 Apr 1904
11
William A Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.8.2]
b. 31 Jul 1856 d. 1862
11
Mary Elizabeth Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.8.3]
b. 21 Nov 1858 d. 15 Jul 1932
Eugene Horace Chamberlain
b. 21 Mar 1855 d. 5 May 1930
12
Clara Elizabeth Chamberlain
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.8.3.1]
b. 12 Sep 1887 d. 4 Jan 1959 [
=>
]
12
Edward Clayton Chamberlain
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.8.3.2]
b. 14 Jan 1889 d. Abt 1970
12
Ralph Leo Chamberlain
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.8.3.3]
b. 17 Jul 1890 d. 6 Dec 1978 [
=>
]
12
George Wallace Chamberlain
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.8.3.4]
b. 28 May 1892 d. 3 Feb 1962
12
Alice Mary Chamberlain
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.8.3.5]
b. 21 Apr 1895 d. 6 Jul 1972
12
Joseph E Chamberlain
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.8.3.6]
b. 25 Jan 1900 d. 8 Aug 1902
11
George Harold Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.8.4]
b. 28 Oct 1860
Elizabeth Sherwood
b. Jan 1872
12
George Harold Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.8.4.1]
b. 20 Jul 1899 d. 1985
12
Howard Andrew Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.8.4.2]
b. 21 Feb 1905 d. 25 Dec 1988
12
Robert E Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.8.4.3]
b. 1909 d. 1995
11
Rosanna William Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.8.5]
b. 23 Dec 1862 d. 1869
11
Charles J Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.8.6]
b. 1864 d. 1869
11
Charles J Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.8.7]
10
James Loren Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.9]
b. 28 Feb 1825 d. 6 Dec 1900
Irene Jane Haynes
b. 20 Nov 1827 d. 20 Feb 1905
11
Son Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.9.1]
b. 1848 d. 1848
11
Judson Wells Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.9.2]
b. 30 Dec 1851 d. 23 Oct 1936
Sarah Suddaby
b. 20 Mar 1857 d. 22 Apr 1915
12
Ora Arminta Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.9.2.1]
b. 23 Jun 1877 d. 27 Sep 1944 [
=>
]
12
Dott Irene Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.9.2.2]
b. 27 Nov 1880 d. 15 Jan 1964
12
John Blakselee Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.9.2.3]
b. 17 Jan 1887
12
Ward Suddaby Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.9.2.4]
b. 7 Aug 1893
11
Antonette Jane Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.9.3]
b. 4 Jul 1856 d. 6 Apr 1863
11
Cora Marietta Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.9.4]
b. 26 Nov 1859 d. 19 Feb 1896
11
Rose Jane Wheelock
[1.3.1.1.1.4.2.5.4.9.5]
b. 8 Dec 1871 d. 1 Feb 1894
8
Aaron Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.6]
b. 12 Mar 1757 d. 3 Jun 1759
8
Lidia Daggett
[1.3.1.1.1.4.2.7]
b. 4 Oct 1758 d. 23 Mar 1836
Naham Lamb
b. 13 Jul 1759 d. 22 May 1842
9
Amasa Lamb
[1.3.1.1.1.4.2.7.1]
b. 24 Jul 1786 d. 12 Jun 1815
9
Linda Lamb
[1.3.1.1.1.4.2.7.2]
b. 14 Oct 1788
+
Caleb Knight
b. 16 Sep 1780
9
Patee Lamb
[1.3.1.1.1.4.2.7.3]
b. 10 Jan 1791
9
Nahum Lamb
[1.3.1.1.1.4.2.7.4]
b. 4 Aug 1793
9
Lydia Lamb
[1.3.1.1.1.4.2.7.5]
b. 3 Feb 1796
9
Jason Lamb
[1.3.1.1.1.4.2.7.6]
b. 9 Oct 1798 d. 2 Aug 1873
Nancy Cruver
b. 5 Nov 1804 d. 14 Nov 1843
10
Salem Towne Lamb
[1.3.1.1.1.4.2.7.6.1]
b. 15 Oct 1823
10
George Washington Lamb
[1.3.1.1.1.4.2.7.6.2]
b. 1825
10
Erastus Wallace Lamb
[1.3.1.1.1.4.2.7.6.3]
b. 1826
10
Melinda Mary Lamb
[1.3.1.1.1.4.2.7.6.4]
b. 1829
10
Leonard Lamb
[1.3.1.1.1.4.2.7.6.5]
b. 1830 d. 1858
Melinda W Harmon
b. 17 Apr 1810 d. 31 Aug 1883
10
Ellen E Lamb
[1.3.1.1.1.4.2.7.6.6]
b. 1846 d. Bef 1923
Charles Henry Williams
b. 21 Jun 1845 d. 5 Jan 1911
11
Thomas Harmon Williams
[1.3.1.1.1.4.2.7.6.6.1]
b. 1867
11
Lora A Williams
[1.3.1.1.1.4.2.7.6.6.2]
b. 1871
11
Wallace J Williams
[1.3.1.1.1.4.2.7.6.6.3]
b. 1874
11
Kate Williams
[1.3.1.1.1.4.2.7.6.6.4]
b. 1877
10
Asenath H Lamb
[1.3.1.1.1.4.2.7.6.7]
b. Abt 1849 d. Bef 1923
10
Kate Lamb
[1.3.1.1.1.4.2.7.6.8]
b. 19 Dec 1853 d. 11 Jul 1936
Seba Samuel Bedient
b. 27 Aug 1855 d. 21 Jun 1917
11
Ona Elizabeth Bedient
[1.3.1.1.1.4.2.7.6.8.1]
b. 31 Jan 1881 d. 8 Sep 1936
11
Mary M Bedient
[1.3.1.1.1.4.2.7.6.8.2]
b. 10 Jun 1888
+
Ira W Livermore
b. Abt 1886
9
Gerson Lamb
[1.3.1.1.1.4.2.7.7]
b. 8 Aug 1800 d. 13 Nov 1885
Lois Fisk Bacon
b. 11 Nov 1801 d. 4 Sep 1884
10
Norval Bacon Lamb
[1.3.1.1.1.4.2.7.7.1]
b. 17 Apr 1827
10
Alvan Naham Lamb
[1.3.1.1.1.4.2.7.7.2]
b. 27 Jul 1828
10
Edwin Dagget Lamb
[1.3.1.1.1.4.2.7.7.3]
b. 18 Jul 1832
10
Henry Gersom Lamb
[1.3.1.1.1.4.2.7.7.4]
b. 27 Feb 1834
Ellen Augusta Bacon
b. 9 Nov 1838
11
Frank Henry Lamb
[1.3.1.1.1.4.2.7.7.4.1]
b. 14 Jun 1856
10
Theodore Fiske Lamb
[1.3.1.1.1.4.2.7.7.5]
b. 2 Sep 1836
10
Charles Francis Lamb
[1.3.1.1.1.4.2.7.7.6]
b. 15 Mar 1838
9
Washington Lamb
[1.3.1.1.1.4.2.7.8]
b. 6 May 1803
7
William Daggett
[1.3.1.1.1.4.3]
b. 15 Aug 1727 d. 15 Jan 1813
Thankful Gleason
b. 17 Jun 1738 d. 28 Dec 1813
8
Asa Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.1]
b. 7 Jul 1760 d. Abt 1830
Waitstill Monroe
b. 2 Jan 1764
9
Asel Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1]
b. 16 Aug 1798 d. 6 Jan 1848
Elizabeth Barnes
b. 1804 d. 1 Jul 1891
10
Ann Elizabeth Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.1]
b. 13 Mar 1829 d. 21 Feb 1901
Luke Teeple
b. Abt 1828 d. 11 Feb 1923
11
Matilda E Teeple
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.1.1]
b. 1 Oct 1848 d. 12 Oct 1951
Edgar A Manning
b. 12 Dec 1844 d. 1907
12
William August Manning
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.1.1.1]
b. 14 Mar 1866 d. 11 Oct 1873
12
James A Manning
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.1.1.2]
b. 10 Feb 1870
12
Minnie E Manning
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.1.1.3]
b. 12 Oct 1872 d. 26 Aug 1913 [
=>
]
12
Nellie Ann Manning
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.1.1.4]
b. 31 Aug 1875 d. 17 Oct 1972 [
=>
]
12
Luke Philip Manning
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.1.1.5]
b. 3 May 1878 d. 19 Jan 1969
12
Clarence Gilbert Manning
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.1.1.6]
b. 15 May 1881 d. 12 Oct 1960
12
Dell Lee Manning
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.1.1.7]
b. 5 Apr 1884 d. 11 Apr 1975 [
=>
]
12
Harry Manning
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.1.1.8]
b. Mar 1889 bur. 25 Jun 1914
12
Asa William Manning
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.1.1.9]
b. 3 May 1891 d. 15 Jun 1974
11
George Teeple
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.1.2]
b. Abt 1852 d. 27 Jan 1941
+
Ida Darval
b. 1861
11
Edgar Elisha Teeple
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.1.3]
b. 1855 d. 25 Dec 1942
Idell Percey
b. 16 Mar 1860
12
Beulah Teeple
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.1.3.1]
b. 4 May 1891 d. Sep 1913
11
Asa Henry Teeple
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.1.4]
b. 23 Mar 1857 d. 18 May 1940
Mary Elizabeth Dawson
b. 1 Nov 1857 d. 28 May 1943
12
Guy H Teeple
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.1.4.1]
b. 2 Oct 1876 d. Sep 1963 [
=>
]
12
Anna Elizabeth Teeple
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.1.4.2]
b. 20 Nov 1878 d. 23 Nov 1963 [
=>
]
11
Helen Elizabeth Teeple
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.1.5]
b. 19 Apr 1857 d. 1904
11
Simon Peter Teeple
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.1.6]
b. 1860
Clara Marean
b. 1863
12
Glenn R Teeple
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.1.6.1]
b. 1891
12
Jennie Adell Teeple
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.1.6.2]
b. 4 Mar 1893
11
Jessie Teeple
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.1.7]
b. 6 Jul 1860 d. 8 Apr 1862
11
Minnie E Teeple
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.1.8]
b. 15 Sep 1862 d. 7 Nov 1870
11
Florence A Teeple
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.1.9]
b. 1864
+
Jaron L Marks
11
Sherman Ulyssees Teeple
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.1.10]
b. 27 Sep 1869
+
Mary E Davis
b. 23 Sep 1869
10
Jefferson Loren Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.2]
b. 1 Jan 1838 d. 16 Jun 1919
Mary Jane Ward
b. 6 Aug 1842 d. 14 Feb 1899
11
William Henry Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.2.1]
b. 16 Feb 1862 d. 27 May 1918
Sarah Ann Lord
b. 4 May 1861 d. 14 Jun 1932
12
Bertha Jane Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.2.1.1]
b. 28 Mar 1883 d. 23 Jun 1965
12
Dora Adelia Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.2.1.2]
b. 29 Aug 1886 d. 13 Oct 1968
12
Earl Henry Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.2.1.3]
b. 11 Nov 1888 d. 26 Nov 1947
12
Edith Ethel Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.2.1.4]
b. 18 Nov 1893
12
Erwin J Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.2.1.5]
b. 6 Jun 1898 d. 3 Dec 1968
11
Elisha Strong Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.2.2]
b. 7 Dec 1868 d. 16 Oct 1946
Edith F Wheeler
b. 23 Feb 1871 d. 1 Oct 1963
12
Harry Arthur Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.2.2.1]
b. 5 Oct 1890
12
Roy Jefferson Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.2.2.2]
b. 30 Dec 1893 d. 8 May 1972 [
=>
]
12
Robert Charles Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.2.2.3]
b. 22 Jan 1896 d. 3 Aug 1948
12
Mary Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.2.2.4]
b. Aug 1898
12
Jessie I Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.2.2.5]
b. 2 Feb 1902 d. Dec 1987 [
=>
]
12
Ethel Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.2.2.6]
b. 1906
11
Orlen Asa Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.2.3]
b. 15 Aug 1869 d. 22 Nov 1948
Elma Jeanette Boyington
b. 22 Jun 1874 d. 6 Apr 1904
12
Lilly Emerille Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.2.3.1]
b. 12 May 1892 d. 28 Jul 1980 [
=>
]
12
Rose Ethel Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.2.3.2]
b. 11 Oct 1893 d. 8 Feb 1970 [
=>
]
12
Bertha Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.2.3.3]
b. 1895 d. 1900
12
Silas Orlin Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.2.3.4]
b. 1 Apr 1898 d. 8 Feb 1970
12
Ruby Janette Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.2.3.5]
b. 3 Jan 1900 d. 30 Aug 1953 [
=>
]
12
Pearl Faith Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.2.3.6]
b. 19 Jul 1902 d. 15 Jan 1984 [
=>
]
12
Jay Spencer Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.2.3.7]
b. 6 Apr 1904 d. 28 Sep 1958
11
Loran Elias Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.2.4]
b. 6 Jun 1872 d. 18 Mar 1935
Myra May Butler
b. Abt 1870
12
Leon L Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.2.4.1]
b. 1895
11
Andrew James Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.2.5]
b. 3 Feb 1874 d. 5 Feb 1936
Maude Annie Butler
b. Abt 1874
12
Florence M Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.2.5.1]
b. 1900
12
Hazel Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.2.5.2]
b. 1904
11
Truman Briant Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.2.6]
b. 6 Mar 1876 d. 31 Oct 1955
Ella May Earl
b. 22 Oct 1878 d. 25 Jun 1939
12
Floyd E Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.2.6.1]
b. 3 Aug 1905 d. Aug 1980
12
Nellie Viola Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.2.6.2]
b. 15 Dec 1906 d. 19 Mar 2007
12
Richard J Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.2.6.3]
b. 8 Mar 1915 d. Nov 1969
11
Homer Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.2.7]
b. Abt 1877
11
Charles Grant Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.2.8]
b. 29 Sep 1880 d. 14 Oct 1943
Violet May Bumpus
12
Harley L Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.2.8.1]
b. 5 Dec 1913 d. 15 Sep 1998
11
Delbert LeRoy Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.2.9]
b. 2 Sep 1882 d. 4 Jun 1951
Selma Rohde
b. Abt 1882 d. 1932
12
Loren Julius Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.2.9.1]
b. 2 Nov 1915 d. 29 Nov 1988
12
LeRoy Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.2.9.2]
b. 1 Aug 1925 d. 9 Dec 1991
12
James Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.2.9.3]
b. 14 Nov 1929 d. Aug 1987
10
Julia Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.3]
b. 28 May 1837 d. 22 Apr 1921
Sidney A Crosby
b. 1831 d. 15 Sep 1901
11
Elery Adelbert Crosby
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.3.1]
b. 11 Dec 1858 d. 20 Nov 1943
Lucy Amelia Powers
b. 24 Sep 1863 d. 5 Jul 1934
12
George Henry Crosby
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.3.1.1]
b. 4 Apr 1882 d. 9 Dec 1971 [
=>
]
12
Mainard Elery Crosby
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.3.1.2]
b. 26 Sep 1884 d. 19 Jun 1976 [
=>
]
12
Elmer Adelbert Crosby
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.3.1.3]
b. 23 Jul 1887 d. 27 Nov 1979 [
=>
]
12
Mary Belle Crosby
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.3.1.4]
b. 18 Mar 1891 d. 19 Mar 1944 [
=>
]
11
Carrie Bell Crosby
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.3.2]
b. 1861 d. 5 Nov 1932
Will N Garrett
b. 6 Jan 1854 d. 1 Dec 1926
12
Emma Garrett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.3.2.1]
b. 20 Jun 1881 d. 3 Feb 1916
12
Thomas Garrett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.3.2.2]
b. Mar 1882
12
Julia Garrett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.3.2.3]
b. Jul 1884
11
Laura Elizabeth Crosby
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.3.3]
b. 2 Nov 1863 d. 18 Nov 1934
Henry Franklin Garrett
b. 4 Jun 1858 d. 8 Aug 1919
12
Dorothy Garrett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.3.3.1]
b. 1 Apr 1881 d. 1 Nov 1960 [
=>
]
12
Adelbert D Garrett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.3.3.2]
b. Sep 1890
12
Nellie M Garrett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.3.3.3]
b. Oct 1892
12
William Wallace Garrett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.3.3.4]
b. Jun 1894
12
Benjamin T Garrett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.3.3.5]
b. Jul 1897
12
Mark Hanna Garrett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.3.3.6]
b. Feb 1900
11
Henry Foster Crosby
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.3.4]
b. 18 May 1868 d. 21 Jan 1958
Theresa Mary Gerwein
b. 9 Feb 1870 d. Abt 1930
12
Martin Edward Crosby
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.3.4.1]
b. 31 Oct 1895 d. 23 Oct 1990
12
Mary Frances Crosby
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.3.4.2]
b. 6 Oct 1897
12
Lydia Crosby
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.3.4.3]
b. Mar 1900
12
Alma Bertha Crosby
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.3.4.4]
b. Abt 1902
12
Delbert E Crosby
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.3.4.5]
b. 1903
12
Clifford Crosby
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.3.4.6]
b. 11 Nov 1907 d. 20 May 1986
11
George Marshal Crosby
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.3.5]
b. 27 Oct 1870 d. 16 Dec 1922
+
Eva George
b. Abt 1883
11
Mary Crosby
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.3.6]
b. 1879 d. 1879
10
Elisha S Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.4]
b. 1839
10
Electa Elizabeth Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.5]
b. Sep 1844
Delos D Stetson
b. 1837 d. 10 Jul 1884
11
Florence Stetson
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.5.1]
b. Mar 1870
11
Alvin Stetson
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.5.2]
b. 1872
11
Georgia Stetson
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.5.3]
b. 9 Mar 1875 d. Sep 1949
Henry LaBrash
b. 1856
12
Robert George LaBrash
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.5.3.1]
b. 11 Feb 1905 d. 5 Mar 1955
+
Henry J Porter
b. Jan 1840 d. 6 Apr 1918
10
Mary Louisa Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.6]
b. 1847
Marshall Lee Daggett
b. 12 Jan 1848
11
Robert Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.6.1]
b. 11 Nov 1869
11
Son Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.6.2]
b. 17 Nov 1869
11
Blanch Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.6.3]
b. 10 Aug 1874 d. 9 Mar 1880
11
Myron Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.1.1.6.4]
b. 14 Jul 1886 d. 13 May 1887
8
Anna Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.2]
b. 11 Sep 1762 d. Aft 1788
William Estey
b. 9 Aug 1759 d. 1843
9
Nabby Estey
[1.3.1.1.1.4.3.2.1]
b. 8 Jul 1791
9
Fanny Estey
[1.3.1.1.1.4.3.2.2]
b. 28 Mar 1793
9
Betsey Estey
[1.3.1.1.1.4.3.2.3]
b. 26 Apr 1795
9
Anna Estey
[1.3.1.1.1.4.3.2.4]
b. 25 Aug 1797
9
Gilman Estey
[1.3.1.1.1.4.3.2.5]
b. 14 Oct 1799 d. 14 Oct 1877
+
Louisa Thompson
b. 29 Apr 1819 d. 22 Feb 1885
9
Caroline Estey
[1.3.1.1.1.4.3.2.6]
b. 27 Dec 1801
+
George Rice
b. 1807
8
Phineas Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.3]
b. 22 Aug 1764
Betsey Wilson
b. 1769 d. 11 Aug 1791
9
William Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.3.1]
b. 21 Dec 1788 d. 2 Jun 1818
Clarissa Wait
b. 1791 d. 1862
10
William Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.3.1.1]
b. 1813 d. 16 May 1860
10
Clarissa Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.3.1.2]
b. 6 Mar 1815 d. 10 Nov 1890
Sidney Smith Campbell
b. 3 Mar 1810 d. 26 Feb 1896
11
Mary Elizabeth Campbell
[1.3.1.1.1.4.3.3.1.2.1]
b. 28 Aug 1836 d. 16 Mar 1871
11
Charles Sidney Campbell
[1.3.1.1.1.4.3.3.1.2.2]
b. Abt 1838
11
Clara Anna Campbell
[1.3.1.1.1.4.3.3.1.2.3]
b. Abt 1840
10
George Wait Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.3.1.3]
b. 30 Jun 1818 d. 25 Jun 1884
Sarah Lauretta Cole
b. 7 Mar 1821
11
George Marshall Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.3.1.3.1]
b. 16 Oct 1848 d. 11 Jul 1862
11
Sarah Louise Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.3.1.3.2]
b. 19 May 1850 d. 23 Dec 1881
Thomas Smith Merrill
b. 8 Sep 1836 d. 28 Dec 1909
12
Maud Evylin Merrill
[1.3.1.1.1.4.3.3.1.3.2.1]
b. 26 Mar 1873
12
Blanche Auretta Merrill
[1.3.1.1.1.4.3.3.1.3.2.2]
b. 12 Oct 1875 [
=>
]
11
Clara Esther Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.3.1.3.3]
b. 3 Mar 1852
William Graves Leonard
b. 3 Feb 1853 d. 5 Apr 1933
12
Wallace Cole Leonard
[1.3.1.1.1.4.3.3.1.3.3.1]
b. 20 Mar 1877
12
Eva louise Leonard
[1.3.1.1.1.4.3.3.1.3.3.2]
b. 25 Jun 1879 d. 21 Mar 1889
11
Walter Sidney Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.3.1.3.4]
b. 1855 d. 31 Mar 1901
Flora Lucinda Evans
b. 21 Jul 1861 d. 14 Jun 1954
12
Lewis E Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.3.1.3.4.1]
b. 21 Aug 1895 d. May 1979
12
Frank Heber Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.3.1.3.4.2]
b. 31 Aug 1896 d. 2 Nov 1981
12
Walter S Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.3.1.3.4.3]
b. 1901
11
Eliza Elizabeth "Lillie Bell" Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.3.1.3.5]
b. 30 Jun 1857 d. 22 Jul 1862
10
Eliza Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.3.1.4]
b. 2 Oct 1817
Stephen Kimball Cutter
b. 12 Mar 1815
11
Frances Eveline Cutter
[1.3.1.1.1.4.3.3.1.4.1]
b. 28 Apr 1839 d. 14 Sep 1859
+
Veranis Bemis Coleman
b. 21 Jan 1837
11
Judson Charles Cutter
[1.3.1.1.1.4.3.3.1.4.2]
b. 30 Jul 1842
11
Addison Adolphus Cutter
[1.3.1.1.1.4.3.3.1.4.3]
b. 20 Apr 1845 d. 26 Jun 1845
11
Addison Adolphus Cutter
[1.3.1.1.1.4.3.3.1.4.4]
b. 5 Oct 1846 d. 7 Jul 1906
Arabella Mathilda "Bella" Flanders
b. 1852 d. 17 May 1943
12
Elizabeth Cutter
[1.3.1.1.1.4.3.3.1.4.4.1]
b. 1879 d. 16 Feb 1884
12
Louise C Cutter
[1.3.1.1.1.4.3.3.1.4.4.2]
b. 1885 d. Nov 1971
12
Helen Catharine Cutter
[1.3.1.1.1.4.3.3.1.4.4.3]
b. 17 Jan 1887 d. 24 Apr 1974 [
=>
]
11
Ella Eliza Cutter
[1.3.1.1.1.4.3.3.1.4.5]
b. 30 Mar 1849
9
Artemas Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.3.2]
b. 17 Jul 1790 d. 1835
Sally Smith
b. Abt 1792
10
Daughter Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.3.2.1]
b. Abt 1806
10
Daughter Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.3.2.2]
b. Abt 1808
10
Daughter Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.3.2.3]
b. Abt 1810
Marcy Pierce
b. 6 Aug 1771 d. 29 Jun 1850
9
Polly Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.3.3]
b. 6 Aug 1795 d. 6 Aug 1802
9
Hiram Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.3.4]
b. 9 Aug 1797 d. 1 Jan 1832
9
Betsey Dagget
[1.3.1.1.1.4.3.3.5]
b. 31 Dec 1799 d. 1877
Broughton Knight
b. 25 Feb 1798 d. 4 Feb 1854
10
Allona B Knight
[1.3.1.1.1.4.3.3.5.1]
b. Abt 1833 d. 17 Dec 1869
10
Phila Knight
[1.3.1.1.1.4.3.3.5.2]
b. Apr 1836
10
George P Knight
[1.3.1.1.1.4.3.3.5.3]
b. Aug 1840
9
Hollis Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.3.6]
b. 4 Nov 1802 d. 1882
Flora Jackman
b. Abt 1806
10
Frederick Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.3.6.1]
b. Abt 1826
10
Daughter Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.3.6.2]
b. Abt 1828
9
Lewis Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.3.7]
b. 15 Aug 1804
Harriet Haughton
b. 7 Aug 1807 d. 10 Aug 1866
10
Hiram Sibley Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.3.7.1]
b. 3 Feb 1833 d. 25 Nov 1861
10
Carolina Louisa Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.3.7.2]
b. 7 Jun 1837 d. 14 Feb 1339
10
Henry Talmadge Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.3.7.3]
b. 8 Feb 1840
Mary Eaton
b. 27 Jun 1840 d. 28 Apr 1884
11
Frankie Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.3.7.3.1]
b. 8 Jun 1869 d. 3 Sep 1869
11
William L Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.3.7.3.2]
b. 1 Aug 1871
11
Mary Harriet Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.3.7.3.3]
b. 5 Mar 1884
10
Charles Prentice Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.3.7.4]
b. 5 Oct 1843 d. 14 Jan 1846
10
Charles Lewis Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.3.7.5]
b. 14 Jan 1851 d. 25 Feb 1869
9
Prentis Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.3.8]
b. 25 Aug 1807 d. 29 Oct 1881
9
Mary Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.3.9]
b. 1809 d. 1841
Daniel Pierce
b. 1808
10
Darwin Pierce
[1.3.1.1.1.4.3.3.9.1]
b. Abt 1836
10
Horace Pierce
[1.3.1.1.1.4.3.3.9.2]
b. Abt 1838
9
Louisa Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.3.10]
b. 10 Dec 1812
Moses Knapp Pratt
b. 1 Jan 1813 d. 15 Mar 1884
10
Frederic Knight Pratt
[1.3.1.1.1.4.3.3.10.1]
b. 25 May 1843
Marion B Turnure
b. 1854
11
Frank Hollis Pratt
[1.3.1.1.1.4.3.3.10.1.1]
b. 25 Nov 1877
11
Ralph Turnure Pratt
[1.3.1.1.1.4.3.3.10.1.2]
b. 22 Apr 1884
8
Nathaniel Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.4]
b. 1766 d. 16 Jun 1852
Electa Roberts
b. 12 Dec 1771 d. 27 Oct 1856
9
Harry Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.4.1]
b. 1793 d. 14 Nov 1869
Julia Crane
b. 1797 d. 25 Dec 1890
10
Julia Ann Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.4.1.1]
b. 29 Jul 1820
10
Harry Crane Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.4.1.2]
b. 24 Dec 1821
Nancy D Whitcomb
b. 2 Oct 1833 d. 28 Nov 1906
11
Milton H Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.4.1.2.1]
b. Mar 1858 d. 1935
Asenath Sprague Voter
b. 15 Aug 1865 d. 11 Jan 1954
12
Earle Voter Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.4.1.2.1.1]
b. 20 Apr 1888
12
Harry Clarence Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.4.1.2.1.2]
b. 7 Apr 1893 d. Jan 1971 [
=>
]
12
Mildred Maude Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.4.1.2.1.3]
b. 11 Sep 1895 d. 16 Dec 1990
10
Royal Montraville Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.4.1.3]
b. 9 Sep 1823
Adeline L Weeden
b. 25 Jul 1824
11
Emera Montraville Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.4.1.3.1]
b. 1853 d. 1926
Dora A Herrick
b. 16 Nov 1857 d. 3 Dec 1908
12
Alfred E Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.4.1.3.1.1]
b. 31 Aug 1879 d. 19 Jul 1965
12
Bernice Julia Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.4.1.3.1.2]
b. 17 May 1895 d. 11 Mar 1977
10
Carlos Manson Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.4.1.4]
b. 1 Mar 1827
10
Oscar Fitzwilliam Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.4.1.5]
b. 11 May 1833 d. Aft 1880
Mary Dillocy Brooks
b. 8 Mar 1840 d. Aft 1863
11
Ida M Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.4.1.5.1]
b. 1866
9
Shubael Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.4.2]
b. 1797
9
Orville Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.4.3]
b. 1799
9
Celista Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.4.4]
b. 1801 d. 6 Jan 1862
9
Phineas Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.4.5]
b. 1802
9
Phinehas Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.4.6]
b. 9 Aug 1802 d. 30 Oct 1877
Emeline Boynton
b. 29 Jul 1807 d. 6 Feb 1881
10
Pemelia Anne Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.4.6.1]
b. 17 Apr 1829 d. 5 Jul 1883
10
Hallis Boynton Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.4.6.2]
b. 28 Dec 1830 d. 14 Feb 1835
10
Lillian Sarah Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.4.6.3]
b. 3 Dec 1832 d. 20 Oct 1861
George James
b. 3 Apr 1827 d. 22 May 1902
11
Ellen Eudora James
[1.3.1.1.1.4.3.4.6.3.1]
b. 5 May 1851 d. 28 Jan 1908
11
Myra Louisa James
[1.3.1.1.1.4.3.4.6.3.2]
b. 5 Oct 1852 d. 15 Jul 1926
Robert Blum Reinhardt
b. 14 Jan 1849 d. 29 Dec 1929
12
Robert Reinhardt
[1.3.1.1.1.4.3.4.6.3.2.1]
b. Abt 1873
12
Lillian Sarah Reinhardt
[1.3.1.1.1.4.3.4.6.3.2.2]
b. 29 Oct 1874 d. 1 Dec 1954 [
=>
]
12
George Frederick Reinhardt
[1.3.1.1.1.4.3.4.6.3.2.3]
b. 2 Jan 1877 d. 25 Jun 1931 [
=>
]
11
Sarah Lillian James
[1.3.1.1.1.4.3.4.6.3.3]
b. 31 Jan 1856 d. 1921
10
May Miriah Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.4.6.4]
b. 10 Feb 1836
10
Mary M Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.4.6.5]
b. 10 Feb 1836
10
Harriet B Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.4.6.6]
b. 11 Sep 1837
10
Joseph Nathaniel Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.4.6.7]
b. 17 Nov 1839 d. 24 Mar 1902
10
Emeline Arethusa Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.4.6.8]
b. 25 Sep 1841 d. 15 Oct 1910
George James
b. 3 Apr 1827 d. 22 May 1902
11
Rosa Beatrice James
[1.3.1.1.1.4.3.4.6.8.1]
b. 29 May 1866
Charles Robert Piper
b. 25 May 1862
12
Harold Raymond Piper
[1.3.1.1.1.4.3.4.6.8.1.1]
b. 15 Apr 1892 d. 28 Apr 1914
12
Majorie Boynton Piper
[1.3.1.1.1.4.3.4.6.8.1.2]
b. 19 Apr 1897 d. 10 Mar 1987 [
=>
]
11
Edward James
[1.3.1.1.1.4.3.4.6.8.2]
b. 1871 d. 1875
10
Loretta Lamar Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.4.6.9]
b. 27 May 1844
10
Ellen Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.4.6.10]
b. 1 Nov 1846
10
Abbie Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.4.6.11]
b. 17 Apr 1848
9
Nathaniel Daggett, Jr
[1.3.1.1.1.4.3.4.7]
b. 1804
9
Alpheus Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.4.8]
b. 1807
9
Samuel Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.4.9]
b. 1810
9
Philarmon Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.4.10]
b. 1812
9
Amos Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.4.11]
b. 1814
9
Electa Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.4.12]
b. 1816
8
Susan Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.5]
b. Abt 1768
John Rice
b. 1764 d. 1841
9
Nancy Rice
[1.3.1.1.1.4.3.5.1]
b. 1789
+
Luther Denison
b. Abt 1787
+
Jeremiah Robbins
b. Abt 1785
9
John Rice
[1.3.1.1.1.4.3.5.2]
b. 1791 d. Aft 1824
Eliza Burke
b. 29 May 1797
10
Ebed Burke Rice
[1.3.1.1.1.4.3.5.2.1]
b. Abt 1824
9
Mary "Polly" Rice
[1.3.1.1.1.4.3.5.3]
b. 1793 d. 1854
Samuel Nichols
b. 1772
10
Caroline E Nichols
[1.3.1.1.1.4.3.5.3.1]
b. 1818 d. 3 Aug 1903
William Storer
b. 1817
11
Ellen Maria Storer
[1.3.1.1.1.4.3.5.3.1.1]
b. 2 Jun 1847 d. 22 Nov 1896
11
Eliza M Storer
[1.3.1.1.1.4.3.5.3.1.2]
b. 20 Jun 1847 d. Bef 1855
11
William Nichols Storer
[1.3.1.1.1.4.3.5.3.1.3]
b. 16 Sep 1849 d. 7 Jun 1909
Emma Frances Chesley
b. 11 Apr 1853
12
Eliot Chesley Storer
[1.3.1.1.1.4.3.5.3.1.3.1]
b. 7 Oct 1887
12
Paul Nichols Storer
[1.3.1.1.1.4.3.5.3.1.3.2]
b. 8 Nov 1891
11
Henry Johnson Storer
[1.3.1.1.1.4.3.5.3.1.4]
b. 28 Aug 1860 d. 1 May 1935
+
Bernice Lavina Georgiana Olive
b. 7 Apr 1872 d. Bef 1990
9
Lewis Rice
[1.3.1.1.1.4.3.5.4]
b. 1796 d. 1835
9
Louisa Rice
[1.3.1.1.1.4.3.5.5]
b. 1798
+
Gilman Esty
9
Fannie Rice
[1.3.1.1.1.4.3.5.6]
b. 1800 d. Aft 1821
Tyler Curtis Knight
b. 23 Aug 1797 d. 22 Apr 1855
10
Lucretia Knight
[1.3.1.1.1.4.3.5.6.1]
d. 22 Apr 1855
+
Charles A Towne
9
Lucinda Rice
[1.3.1.1.1.4.3.5.7]
b. 1802
+
John Bryant
b. Abt 1800
9
Horace Rice
[1.3.1.1.1.4.3.5.8]
b. 1804
9
Emily Rice
[1.3.1.1.1.4.3.5.9]
b. 1809
+
Thurman Richardson
b. Abt 1805
9
Susan Rice
[1.3.1.1.1.4.3.5.10]
b. 1811
+
Calvin B Meade
b. Abt 1807
9
George Rice
[1.3.1.1.1.4.3.5.11]
b. 1807
+
Caroline Estey
b. 27 Dec 1801
8
Hannah Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.6]
b. 1770
+
Horton
8
Sarah Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.7]
b. Abt 1772
8
Amos Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.8]
b. Abt 1772
8
Daughter Daggett
[1.3.1.1.1.4.3.9]
b. Abt 1774
+
William Ide
7
Arthur Daggett
[1.3.1.1.1.4.4]
b. 30 Jan 1730 d. 23 Aug 1775
Mehitable King
b. 8 May 1731 d. 13 Mar 1809
8
Arthur Daggett, Jr
[1.3.1.1.1.4.4.1]
b. 23 Apr 1751 d. 25 Aug 1835
Lucy Cutler
b. 17 Apr 1749 d. 23 Feb 1813
9
Arthur Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.1.1]
b. 13 Sep 1774 d. 11 Jan 1855
Azuba Haskell
b. 8 Mar 1768
10
Arthur Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.1.1.1]
b. 4 Apr 1803
10
Freeman Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.1.1.2]
b. 20 Jun 1807
Calista Ingalls
b. 9 Jan 1809 d. 30 Aug 1886
11
George Dagget
[1.3.1.1.1.4.4.1.1.2.1]
b. 18 Sep 1835 d. 1885
+
Sarah Emeline Hamblin
b. 12 Nov 1839 d. Aft 1863
9
Stephen Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.1.2]
b. 7 Mar 1776 d. 22 Dec 1810
Mary Doty
b. 13 Aug 1781 d. 15 Mar 1855
10
Lucy Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.1.2.1]
b. 28 Jan 1805
Alphena Bliss
b. 13 Nov 1802 d. 1 Feb 1844
11
Catharine Amelia Bliss
[1.3.1.1.1.4.4.1.2.1.1]
b. 31 Aug 1828 d. 12 Feb 1892
John Van Ransselaer Kent
b. 21 Nov 1813 d. 12 Feb 1892
12
Charles Van Kent
[1.3.1.1.1.4.4.1.2.1.1.1]
b. 19 Dec 1857 d. 19 Dec 1945
+
Orlando Morse
b. 21 Aug 1817 d. 14 Jun 1852
11
Caroline Elizabeth Bliss
[1.3.1.1.1.4.4.1.2.1.2]
b. 10 Sep 1840
William Commins Robinson
b. 9 Jun 1838
12
Ida Lucy Robinson
[1.3.1.1.1.4.4.1.2.1.2.1]
b. 19 Apr 1868
10
Catharine Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.1.2.2]
b. 16 Jan 1807 bur. 1887
Levi Robinson
b. 18 Sep 1803 d. 7 Sep 1863
11
Joel Emery Robinson
[1.3.1.1.1.4.4.1.2.2.1]
b. 18 Feb 1834 d. 28 Jul 1863
11
Julius Robinson
[1.3.1.1.1.4.4.1.2.2.2]
b. 9 Mar 1836
Mary Amelia Pierce
b. 31 May 1840 d. 11 Sep 1872
12
Irvin George Robinson
[1.3.1.1.1.4.4.1.2.2.2.1]
b. 22 Jan 1864 d. 13 Dec 1941 [
=>
]
12
Ilda Guella Robinson
[1.3.1.1.1.4.4.1.2.2.2.2]
b. 6 Dec 1865
12
Inda M Robinson
[1.3.1.1.1.4.4.1.2.2.2.3]
b. 13 Apr 1867 d. 1929 [
=>
]
12
Lucy C Robinson
[1.3.1.1.1.4.4.1.2.2.2.4]
b. 1868
11
Otis Vinton Robinson
[1.3.1.1.1.4.4.1.2.2.3]
b. 25 Jul 1838 d. 15 Sep 1863
11
Mary Cherville Robinson
[1.3.1.1.1.4.4.1.2.2.4]
b. 24 Aug 1845 d. 28 Nov 1922
James Kelton Toby
b. 17 Jun 1845 d. 21 Apr 1883
12
Celia Mary Tobey
[1.3.1.1.1.4.4.1.2.2.4.1]
b. 7 Oct 1873
12
Lelia M Toby
[1.3.1.1.1.4.4.1.2.2.4.2]
b. 7 Oct 1876
12
Catherine Laura Tobey
[1.3.1.1.1.4.4.1.2.2.4.3]
b. 8 Oct 1879 [
=>
]
10
James Sullivan Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.1.2.3]
b. 20 Sep 1808
+
Elisabeth Vinton
b. Jul 1812 d. 12 Jun 1850
Fidelia Pratt
b. 1818
11
Abbie Elizabeth Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.1.2.3.1]
b. 22 Sep 1851
+
William Henshaw Daley
d. 4 Nov 1904
10
Marietta Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.1.2.4]
b. 9 Sep 1809 d. 26 Oct 1840
9
John Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.1.3]
b. 22 Dec 1777 d. 26 Aug 1820
Loruhanah Nealy
b. 5 Aug 1782 d. 1814
10
Nealy Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.1]
b. 17 Apr 1803 d. 24 Aug 1824
10
Katherine Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.2]
b. 16 Jan 1807 d. 1887
Ebenezer Chapin
b. 1 May 1800 d. 29 Jan 1874
11
Nealy Adolphus Chapin
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.2.1]
b. 28 Jan 1828 d. 30 Mar 1899
Cordelia Olive Perry
b. 29 Jul 1829
12
William Adolphus Chapin
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.2.1.1]
b. 31 Oct 1852 d. 4 Sep 1868
12
Eben Hubert Chapin
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.2.1.2]
b. 21 Nov 1854 d. 8 Feb 1909 [
=>
]
12
Florence Chapin
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.2.1.3]
b. 9 Dec 1856 d. 18 May 1931 [
=>
]
12
Kate Bertha Chapin
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.2.1.4]
b. 9 Sep 1859 d. 27 Nov 1949 [
=>
]
12
Frederick Lincoln Chapin
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.2.1.5]
b. 16 Jun 1863 d. 19 Dec 1913 [
=>
]
12
Jennie Mary Chapin
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.2.1.6]
b. 11 Dec 1865 d. 15 Sep 1936 [
=>
]
12
Laura Annie Chapin
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.2.1.7]
b. 4 Apr 1869 [
=>
]
12
William Robert Chapin
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.2.1.8]
b. 24 Mar 1875 d. 5 Dec 1905
11
Jane Chapin
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.2.2]
b. 1833
11
Patrick Henry Chapin
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.2.3]
b. 22 Aug 1834 d. 1886
Mary Louise Wadleigh
b. 1837
12
Frank Beverly Chapin
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.2.3.1]
b. 28 Nov 1862 [
=>
]
12
Maud Chapin
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.2.3.2]
b. 11 Jun 1864 d. 11 May 1866
12
Luke Wadleigh Chapin
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.2.3.3]
b. 10 Mar 1867 d. 14 Oct 1921 [
=>
]
12
Willis Chapin
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.2.3.4]
b. 23 Feb 1870 d. 29 Jun 1874
12
Nealy Chapin
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.2.3.5]
b. 8 Sep 1875 d. 12 Jul 1956
11
Mary Ann "Rene" Chapin
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.2.4]
b. 4 Nov 1836 d. Aft 1889
+
John Adams Pence
b. 12 Aug 1830 d. 8 Mar 1912
11
John Ebenezer Chapin
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.2.5]
b. 10 Mar 1840
Sarah Saviela Russel
b. 15 Dec 1845
12
Mary Katherine Capin
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.2.5.1]
b. 5 Mar 1873
12
Olive Russel Chapin
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.2.5.2]
b. 31 May 1876
12
Ernest Chapin
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.2.5.3]
b. 21 Aug 1882
11
Flora Ann Chapin
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.2.6]
b. Abt 1842
11
James Chapin
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.2.7]
b. Abt 1844
12
Nealy Chapin
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.2.7.1]
b. Abt 1870
11
Andrew Gregg Chapin
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.2.8]
b. 13 Sep 1845 d. 10 Apr 1846
10
John Scott Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.3]
b. 22 Feb 1808 d. 14 Jan 1890
+
Sarah Chapin
b. Abt 1810 d. 8 Aug 1865
10
Orpha Edson Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.4]
b. 24 May 1810 d. 9 Jun 1875
+
Willis Edson
b. Abt 1810
Ira Woods
b. 2 Jan 1792 d. 4 Aug 1851
11
Clarissa E Woods
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.4.1]
b. May 1840 d. 10 Sep 1908
Alexander McGowan
b. 20 Jul 1835 d. 23 Jul 1901
12
Ida Lecicena McGowan
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.4.1.1]
b. 16 Sep 1856 d. 14 Mar 1934 [
=>
]
12
Orpha C McGowan
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.4.1.2]
b. Abt 1858 d. Bef 1892 [
=>
]
12
Katherine A McGowan
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.4.1.3]
b. Apr 1862 d. 1954 [
=>
]
12
James Willis McGowan
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.4.1.4]
b. Oct 1870
11
Nealy Chapin Woods
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.4.2]
b. 12 Jun 1842 d. 23 May 1918
Cecelia Loretta Stafford
b. 26 Aug 1842 d. 11 Aug 1914
12
Mildred F "May" Woods
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.4.2.1]
b. 16 Oct 1868 d. Aft 1918
12
Willis E Woods
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.4.2.2]
b. 7 Mar 1870 d. 3 Jun 1870
12
Fred Emmett Woods
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.4.2.3]
b. 21 Nov 1872 d. 29 Sep 1899 [
=>
]
12
Grace Agnes Woods
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.4.2.4]
b. 1 Nov 1875 d. 18 Dec 1966 [
=>
]
12
Nealey Clarance Woods
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.4.2.5]
b. 5 Jun 1880 d. 9 Mar 1881
11
Phebe Woods
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.4.3]
b. Abt 1844 d. Bef 1908
11
Emily Woods
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.4.4]
b. Abt 1846 d. Bef 1908
11
Orpha Woods
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.4.5]
b. 21 Apr 1850 d. 17 Sep 1938
Eugene Preston Foster
b. 4 Apr 1848 d. Abt 1934
12
Orpha W Foster
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.4.5.1]
b. 9 Jun 1875 d. 14 Mar 1973
12
Lucy Adeline Foster
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.4.5.2]
b. 19 Jan 1877 d. 14 Sep 1877
12
Grace Foster
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.4.5.3]
b. 30 Jul 1878 d. 19 Sep 1972 [
=>
]
12
Edith Annie Foster
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.4.5.4]
b. 11 Jul 1881
12
Ida Foster
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.4.5.5]
b. 31 May 1885
12
Alex Cheney Foster
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.4.5.6]
b. 25 Jul 1887 d. 25 Jan 1888
12
Willis Edson Foster
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.4.5.7]
b. 3 Nov 1888 d. 29 Mar 1889
12
Frank Preston Foster
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.4.5.8]
b. 3 Nov 1888 d. 31 Mar 1889
12
Mildred Foster
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.4.5.9]
b. 9 Jul 1892 [
=>
]
12
Eugene Cheney Foster
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.4.5.10]
b. 28 Nov 1895 d. 15 Apr 1903
Abigail Durfee
b. 1780 d. Aug 1820
10
Stephen Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.5]
b. 11 Oct 1816 d. 1833
10
Simeon Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.6]
b. 14 Aug 1818 d. 23 Jun 1898
Martha McCrary Rea
b. 30 Mar 1822 d. 5 Jan 1907
11
Edmond M Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.6.1]
b. 1 Jan 1840 d. 20 Oct 1866
11
Louisa Jane Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.6.2]
b. 24 Jul 1841 d. 3 Dec 1863
John Digby
b. 1836
12
Flora Digby
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.6.2.1]
b. 24 Jul 1841 [
=>
]
11
Elizabeth M Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.6.3]
b. 8 Jan 1844 d. Sep 1844
11
Simeon Taylor Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.6.4]
b. 22 Dec 1846 d. 18 Sep 1935
Nancy Marilla Watson
b. 6 Dec 1850 d. 30 Oct 1934
12
Nealy Ellis Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.6.4.1]
b. 6 Nov 1868 d. 15 Nov 1954 [
=>
]
12
John Scott Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.6.4.2]
b. 28 Aug 1870 d. 19 Jul 1941 [
=>
]
12
Edward Taylor Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.6.4.3]
b. 12 Jul 1872 d. 23 Oct 1934 [
=>
]
12
Willis Ebenezer Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.6.4.4]
b. 11 Apr 1874 d. 5 May 1936 [
=>
]
12
Clara Elnora Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.6.4.5]
b. 14 Mar 1876 d. 13 Jun 1951 [
=>
]
12
Charley Walter Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.6.4.6]
b. 15 Dec 1877 d. 7 Apr 1962 [
=>
]
12
Olive Selona Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.6.4.7]
b. 12 Jan 1881 d. 8 May 1924 [
=>
]
12
George Wesley Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.6.4.8]
b. 18 Mar 1883 d. 15 Mar 1957
12
Clarence Albert Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.6.4.9]
b. 14 Jun 1887 d. 15 May 1888
12
Millia Grace Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.6.4.10]
b. 13 May 1889 d. 18 Dec 1981 [
=>
]
12
Henry Ward "Beecher" Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.6.4.11]
b. 4 Feb 1892 d. 8 Feb 1945 [
=>
]
12
Lewis Rea Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.6.4.12]
b. 16 Sep 1895 d. 3 Jan 1976
11
John Scott Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.6.5]
b. Abt 1848 d. Mar 1850
11
Silas Clark Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.6.6]
b. 13 May 1852 d. 1930
Lucy D Shields
b. 4 Aug 1856 d. 1 Jan 1925
12
Etta May Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.6.6.1]
b. 20 Jan 1874 d. 23 Jul 1905 [
=>
]
12
Florance Elba Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.6.6.2]
b. 6 Dec 1876 d. 22 Nov 1957 [
=>
]
12
Benjamin Henry Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.6.6.3]
b. 14 Mar 1879 d. 10 May 1960 [
=>
]
12
Ruth Elizabeth Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.6.6.4]
b. 5 Jan 1881
12
Viva Pearl Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.6.6.5]
b. Dec 1890
11
Martha Salena Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.6.7]
b. 26 Aug 1859 d. 5 Jan 1902
+
Lewis Franklin Davis
b. 2 Nov 1856
11
Frank Smith Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.6.8]
b. 18 May 1864 d. 1902
Elizabeth Bell Burget
b. 7 May 1869 d. 1939
12
Martha Edna Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.1.3.6.8.1]
b. 2 Feb 1889
9
Simeon Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.1.4]
b. 11 Jun 1779 d. 25 Jan 1823
+
Sallie Putnam
b. 1782
9
Polly Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.1.5]
b. 14 Feb 1781 d. 1 Nov 1813
Amasa Bancroft
b. 19 Mar 1778 d. 6 Feb 1812
10
Lucy Bancroft
[1.3.1.1.1.4.4.1.5.1]
b. 30 Mar 1802
Banabus Hammett Snow
d. 31 May 1873
11
Polly Bancroft Snow
[1.3.1.1.1.4.4.1.5.1.1]
b. 28 Nov 1823 d. 7 Sep 1860
Mark Richardson Putnam
b. 6 Nov 1817 d. 13 May 1873
12
Clarence Frances Putnam
[1.3.1.1.1.4.4.1.5.1.1.1]
b. 7 Mar 1848
11
Kate Daggett Snow
[1.3.1.1.1.4.4.1.5.1.2]
b. 11 Oct 1826
11
Emaline Snow
[1.3.1.1.1.4.4.1.5.1.3]
b. 20 Sep 1829
11
Avis Snow
[1.3.1.1.1.4.4.1.5.1.4]
b. 17 Mar 1832
10
Nancy Bancroft
[1.3.1.1.1.4.4.1.5.2]
b. 1804
10
Cornelius Watrous Bancroft
[1.3.1.1.1.4.4.1.5.3]
b. 1808 d. 22 Jan 1856
+
Lucy B Howard
b. 1808
10
Carlos Bancroft
[1.3.1.1.1.4.4.1.5.4]
b. 20 Mar 1809 d. 24 Oct 1876
Mary E Johnston
b. 4 Jul 1813 d. 15 Sep 1856
11
Jane Sophia Bancroft
[1.3.1.1.1.4.4.1.5.4.1]
b. 1 Oct 1841
11
Arthur Daggett Bancroft
[1.3.1.1.1.4.4.1.5.4.2]
b. 29 Aug 1843
Juliette E Camp
b. 3 Aug 1844
12
Carlos Campbell Bancroft
[1.3.1.1.1.4.4.1.5.4.2.1]
b. 25 Jun 1871 d. 1910 [
=>
]
12
Jane Bancroft
[1.3.1.1.1.4.4.1.5.4.2.2]
b. 27 Feb 1879
11
Carlos Amasa Bancroft
[1.3.1.1.1.4.4.1.5.4.3]
b. 15 Sep 1845 d. 1846
11
Charles Eastman Bancroft
[1.3.1.1.1.4.4.1.5.4.4]
b. 23 Apr 1848 d. 6 Aug 1848
11
Carlos Johnston Bancroft
[1.3.1.1.1.4.4.1.5.4.5]
b. 18 May 1852 d. 6 Aug 1863
11
Frederick Wallace Bancroft
[1.3.1.1.1.4.4.1.5.4.6]
b. 15 Sep 1855
10
Amasa Bancroft
[1.3.1.1.1.4.4.1.5.5]
b. 4 Mar 1811
9
Cate Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.1.6]
b. 4 Apr 1786
9
Lucy Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.1.7]
b. 27 Sep 1789
9
Mehitable Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.1.8]
b. 1793 d. 14 Aug 1844
8
Mehetabel Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.2]
b. 10 Oct 1752 d. 20 Apr 1834
Jonathon Rich
b. 20 Jul 1747 d. 28 Aug 1828
9
Reuben Rich
[1.3.1.1.1.4.4.2.1]
b. 26 Apr 1775
9
Simeon Rich
[1.3.1.1.1.4.4.2.2]
b. 6 Mar 1780 d. 11 Sep 1855
Patty Ward
b. 19 Dec 1779
10
Gibert Rich
[1.3.1.1.1.4.4.2.2.1]
b. 29 Nov 1806
Huldah Gould Lamson
b. 26 Oct 1815 d. 20 Jan 1845
11
Arthur Rich
[1.3.1.1.1.4.4.2.2.1.1]
b. 27 Dec 1841
11
Alonzo Gilbert Rich
[1.3.1.1.1.4.4.2.2.1.2]
b. 20 Oct 1843
10
Loisa Rich
[1.3.1.1.1.4.4.2.2.2]
b. Bef 1809
+
Lewis Blood
b. Abt 1809
10
Diantha Rich
[1.3.1.1.1.4.4.2.2.3]
b. 1 Jun 1817
Robert Craig
b. 30 Oct 1805
11
Esther Craig
[1.3.1.1.1.4.4.2.2.3.1]
b. Abt 1844
11
Martha Craig
[1.3.1.1.1.4.4.2.2.3.2]
b. Abt 1847
11
Emily Lorinda Craig
[1.3.1.1.1.4.4.2.2.3.3]
b. 28 Apr 1851
11
Martha L Craig
[1.3.1.1.1.4.4.2.2.3.4]
b. 9 Jun 1860
Willis Asa Taft
b. 16 Jun 1856
12
Robert Beals Taft
[1.3.1.1.1.4.4.2.2.3.4.1]
b. 7 Jan 1882
12
Arthur Corbin Taft
[1.3.1.1.1.4.4.2.2.3.4.2]
b. 12 May 1890
12
Richard Craig Taft
[1.3.1.1.1.4.4.2.2.3.4.3]
b. 3 Jan 1893
10
Erastus Rich
[1.3.1.1.1.4.4.2.2.4]
b. Sep 1809
10
Lucetta Rich
[1.3.1.1.1.4.4.2.2.5]
b. 8 Mar 1820 d. Aft 1870
+
Cyrus Lamb
b. 2 Nov 1818 d. 12 Apr 1882
10
Louisa Rich
[1.3.1.1.1.4.4.2.2.6]
b. 6 Apr 1812
10
Lorinda Rich
[1.3.1.1.1.4.4.2.2.7]
b. 3 Nov 1814 d. Sep 1844
9
Arthur Rich
[1.3.1.1.1.4.4.2.3]
b. 13 Oct 1777
+
Ruby Titus
b. Abt 1781
9
Cynthia Rich
[1.3.1.1.1.4.4.2.4]
b. Abt 1779
+
Dexter Carbin
b. Abt 1775
9
Jonathan Rich, Jr
[1.3.1.1.1.4.4.2.5]
b. 19 Nov 1782
9
Paul Rich
[1.3.1.1.1.4.4.2.6]
b. 16 Aug 1785
9
Barnabas Rich
[1.3.1.1.1.4.4.2.7]
b. 13 Oct 1787
+
Lucy Nichols
b. 17 May 1796 d. 20 Feb 1868
8
Simeon Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3]
b. 7 Mar 1757 d. 9 May 1819
Anna Dean
b. 1759 d. 9 May 1819
9
Nancy Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.1]
b. Abt 1779
+
Amos Putney
b. 10 Feb 1789
9
Simeon Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.2]
b. 1780 d. 17 Jun 1854
Susan Towle
b. 1795 d. 15 Jul 1874
10
Elias Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.2.1]
b. 1816
+
Mary A
b. 1825
10
Lydia A Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.2.2]
b. 1819
10
Susan T Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.2.3]
b. 1823 d. 22 Oct 1907
10
Mary Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.2.4]
b. 1825 d. 26 May 1863
+
Benson Banton
b. Abt 1823
10
Simeon Orval Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.2.5]
b. 1827
Mary Putnam
b. 1828
11
George Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.2.5.1]
b. 30 Aug 1847
11
Homer Putnam Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.2.5.2]
b. 1850 d. 30 May 1924
Abbie C Cromwell
b. 2 Apr 1869 d. 27 Feb 1949
12
Charles Orville Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.2.5.2.1]
b. 1 Aug 1887 d. May 1960 [
=>
]
12
Jennie I Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.2.5.2.2]
b. 23 Sep 1888 d. Mar 1910
12
Harry C Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.2.5.2.3]
b. 20 Apr 1891 d. 28 Apr 1962
12
Lillian G Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.2.5.2.4]
b. 1899
12
Gilman C Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.2.5.2.5]
b. 1901
12
Edythe M Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.2.5.2.6]
b. 10 May 1906 d. 13 Feb 1947
11
Mary J Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.2.5.3]
b. 1852 d. 1912
+
John Green
b. Abt 1850
11
Morris Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.2.5.4]
b. 1854
Rose E Pomeroy
b. 1859
12
Claude Henry Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.2.5.4.1]
b. 24 Jul 1878 d. Sep 1939 [
=>
]
12
Son Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.2.5.4.2]
b. 1880
12
Son Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.2.5.4.3]
b. 2 Sep 1883
11
Gilman Towle Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.2.5.5]
b. 1859 d. 13 Nov 1930
+
Minnie C Todd
b. Abt 1861
11
Nina Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.2.5.6]
b. Abt 1860
11
Susan Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.2.5.7]
b. 8 Apr 1862
+
Elizabeth King
b. Abt 1825
9
Sally Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.3]
b. 1782
9
Son Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.4]
b. Abt 1784
9
Nathaniel Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5]
b. 12 Jul 1785 d. Abt 1827
Maltilda Farwell
b. 17 Jun 1794 d. 4 Oct 1883
10
Catherine Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.1]
b. 20 Jun 1811 d. 19 Nov 1861
+
Henry John Richardson
c. 18 Jan 1809
10
Lorenzo Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.2]
b. 14 Feb 1813 d. 24 Nov 1889
Henrieta Chipman
b. 5 Oct 1817 d. 12 May 1847
11
John F Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.2.1]
b. 25 Feb 1837 d. 15 Feb 1897
Hanna Dora Mansur
b. 13 Nov 1846 d. 29 Jan 1911
12
Henrietta Deborah Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.2.1.1]
b. 28 Aug 1865 d. 18 Jun 1943 [
=>
]
12
Alford Lorenzo Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.2.1.2]
b. 12 Mar 1867 d. 14 Apr 1949 [
=>
]
12
John William Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.2.1.3]
b. 18 Jan 1869 d. 1 Jun 1932 [
=>
]
12
Charles Henry Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.2.1.4]
b. 9 Oct 1871 d. 9 Jun 1959
12
Helen Adelia Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.2.1.5]
b. 17 Jun 1876 d. 26 Jul 1941 [
=>
]
12
James Arthur Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.2.1.6]
b. 31 Dec 1882 d. 16 Mar 1964 [
=>
]
11
Hannah Matilda Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.2.2]
b. 15 Dec 1838 d. 3 Jan 1905
John Henry Bennett
b. 27 Apr 1839 d. 7 Jul 1897
12
Luther Bennett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.2.2.1]
b. 12 Nov 1858 d. 17 May 1936 [
=>
]
12
John Henry Bennett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.2.2.2]
c. 29 May 1859 d. 19 Aug 1861
12
John Andrew Bennett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.2.2.3]
b. 19 Aug 1860 d. 6 May 1861
12
Phebe Louella Bennett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.2.2.4]
b. 11 Feb 1865 d. 16 Nov 1925 [
=>
]
12
Lorenzo Jesse Bennett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.2.2.5]
b. 31 Mar 1873 d. 10 Apr 1938 [
=>
]
12
Anna Dell Bennett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.2.2.6]
b. 23 Feb 1877 d. 25 Sep 1956 [
=>
]
11
Jane Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.2.3]
b. 5 Aug 1841 d. 3 Sep 1842
11
Melissa Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.2.4]
b. 31 May 1843 d. Aft 1905
11
Helen May Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.2.5]
b. 27 Apr 1845
Benjamin R Dickey
b. 6 May 1836 d. 28 Mar 1878
12
Cassius Dickey
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.2.5.1]
b. Abt 1867 d. 26 Dec 1899 [
=>
]
12
George L Dickey
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.2.5.2]
b. Abt 1871
12
Alberta Hellen "Birdie" Dickey
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.2.5.3]
b. Apr 1875 d. 1953 [
=>
]
12
Cerinda Jane Dickey
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.2.5.4]
b. 9 Jun 1877 d. 12 Dec 1900
11
Sylvester Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.2.6]
b. 30 Apr 1847 d. 30 Apr 1847
Eliza J Jones
b. 4 Mar 1830 d. 1890
11
George Jones Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.2.7]
b. 22 May 1848 d. 26 Feb 1849
11
Francis J Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.2.8]
b. 1 Oct 1849 d. Aft 1905
11
Sarah A Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.2.9]
b. 2 May 1851 d. 1 Dec 1852
11
Nathaniel Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.2.10]
b. 29 May 1853 d. 3 Sep 1934
Madora Jane Laughlin
b. 12 Mar 1862 d. 7 Mar 1919
12
Loren Alfred Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.2.10.1]
b. 9 Jan 1880 [
=>
]
12
Rose Elva Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.2.10.2]
b. 11 Dec 1881 d. 1 Sep 1967
12
Josephine Eva Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.2.10.3]
b. 27 Jun 1884
12
Maude E Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.2.10.4]
b. 18 Feb 1886 d. 28 Oct 1908 [
=>
]
12
Harold Edwin Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.2.10.5]
b. 18 Jul 1892 d. 5 Mar 1967
12
Gladys Ruth Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.2.10.6]
b. 26 Jun 1899 d. 11 Nov 1992 [
=>
]
11
Alice G Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.2.11]
b. 12 Jun 1855
Mary Ann Laken
b. 10 Nov 1813 d. 3 Jun 1905
11
James A Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.2.12]
b. 27 Jan 1860 d. 19 Oct 1934
Sarah Jane Taylor
b. 8 Nov 1866 d. 20 Jul 1939
12
Myrtle Iva Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.2.12.1]
b. 18 Nov 1883 d. 24 Apr 1946 [
=>
]
12
Nellie Mary Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.2.12.2]
b. 3 Mar 1885 d. 6 Mar 1894
12
Bertha Helen Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.2.12.3]
b. 20 Apr 1886 d. 22 Nov 1946
12
Bert Thompson Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.2.12.4]
b. 2 Nov 1886 d. 10 Aug 1952
12
Winifred R Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.2.12.5]
b. 8 Dec 1887 d. 11 Mar 1896
12
Alfred Hiram Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.2.12.6]
b. 19 Nov 1889 d. 10 Aug 1955 [
=>
]
12
Pearl Jane Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.2.12.7]
b. 10 Aug 1891 d. 24 Mar 1924
12
Nell Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.2.12.8]
b. Abt 1890
12
Louella Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.2.12.9]
b. 6 Mar 1894
12
Francine Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.2.12.10]
b. 26 Sep 1895 d. 11 Apr 1966
10
John Farwell Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.3]
b. 2 Apr 1816 d. 21 Jun 1899
Elizabeth Maria Burdick
b. 16 Sep 1821 d. 28 Mar 1899
11
Maria Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.3.1]
b. 1842 d. Abt 1847
11
Byron Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.3.2]
b. 1844
11
Mary Jane Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.3.3]
b. 1845
11
Edwin Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.3.4]
b. 1847
11
Sarah Elizabeth Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.3.5]
b. 2 Jun 1849 d. 28 Aug 1937
Ephraim Easton Rosenberg
b. 10 Oct 1837 d. 18 Jan 1910
12
Ida Emma Rosenberg
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.3.5.1]
b. 22 Dec 1869 d. 8 Feb 1941 [
=>
]
12
Jennie Dora Rosenberg
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.3.5.2]
b. 22 Jan 1871 d. 28 Aug 1872
12
Bert Rosenberg
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.3.5.3]
b. 18 Sep 1876 d. 15 Dec 1943 [
=>
]
12
Ephraim Rosenberg
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.3.5.4]
b. 1877
12
Hattie Blanch Rosenberg
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.3.5.5]
b. 14 Apr 1880 d. 17 Jul 1881
12
James Malcom Rosenberg
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.3.5.6]
b. 5 Sep 1882 d. Feb 1970 [
=>
]
+
Charles Radermacher
b. Abt 1845
11
Catherine Minerva Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.3.6]
b. 8 Feb 1852 d. 1930
Ichabod Hawley
b. 1835 d. Mar 1880
12
Effa Mae Hawley
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.3.6.1]
b. 1869 d. 1870
12
Jennie B Hawley
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.3.6.2]
b. 1871 d. 1872
12
Emily J Hawley
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.3.6.3]
b. 1876 d. 1877
12
Claudia Luella Hawley
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.3.6.4]
b. 1 Aug 1878 d. 3 Sep 1964 [
=>
]
12
Bud Hawley
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.3.6.5]
b. 1880 d. 1889
12
Ichabod Adalbert Hawley
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.3.6.6]
b. 15 Aug 1880
11
Ida Matilda Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.3.7]
b. 9 Jun 1854 d. 13 Apr 1932
Fred Josephus Wilson
b. 25 Feb 1836 d. 24 Oct 1898
12
Alfred Nathaniel Wilson
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.3.7.1]
b. 13 Sep 1875 d. 25 Jul 1967 [
=>
]
12
Frank Wasden Wilson
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.3.7.2]
b. 25 Nov 1877 d. 26 Jun 1938 [
=>
]
12
Pearl Ann Wilson
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.3.7.3]
b. 8 Jun 1880 d. 4 Mar 1881
12
Albert Arthur Wilson
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.3.7.4]
b. 6 Apr 1882 d. Jan 1970
12
Lewis Bernard Wilson
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.3.7.5]
b. 26 Oct 1884
12
Myrtle Ida Wilson
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.3.7.6]
b. 17 Feb 1888 d. 20 Feb 1933
12
Minnie Elizabeth Wilson
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.3.7.7]
b. 9 Jul 1892
12
Jesse Bryan Wilson
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.3.7.8]
b. 22 Jul 1896 d. 24 Dec 1974
11
John Burdick Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.3.8]
b. 15 Oct 1854 d. 2 Nov 1931
Ella Viola Woodard
b. 15 Oct 1853 d. 4 Apr 1933
12
Son Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.3.8.1]
b. 27 Aug 1882 d. Bef 1910
12
Capitola Elizabeth Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.3.8.2]
b. Abt 1888 d. 13 Apr 1931
12
Guy Edward Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.3.8.3]
b. 12 May 1891 d. 18 Oct 1968 [
=>
]
12
Ida May Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.3.8.4]
b. 16 Dec 1892
12
Claudia Matilda Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.3.8.5]
b. 2 Jun 1895 d. 9 Dec 1972
11
James Malcom Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.3.9]
b. 30 Mar 1859 d. 11 Nov 1919
11
Emma Adeline Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.3.10]
b. 18 Nov 1861 d. 26 Oct 1931
Charles Ernest Sumner
b. 26 Apr 1859 d. 27 Sep 1932
12
Myrtle Bernice Sumner
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.3.10.1]
b. 1 Jul 1883 d. 22 Jan 1957 [
=>
]
11
Alvan Nathaniel Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.3.11]
b. Jul 1864 d. 22 Feb 1903
10
Derius Dagget
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.4]
b. 9 Jan 1819 d. 30 Jan 1819
10
Sarah Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.5]
b. 31 Jul 1822 d. May 1922
10
Sophia Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.5.6]
b. 9 Oct 1825
+
James Monroe Sumner
b. 17 Mar 1817 d. 13 Jun 1873
9
Caleb C Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.6]
b. Abt 1790 d. 23 Dec 1879
9
Artemas Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.7]
b. 17 Jul 1790
9
Mary Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.3.8]
b. 10 Nov 1795 d. 18 Aug 1864
Henry C Hooker
b. 5 Jul 1791 d. 17 Mar 1885
10
Amelia Prentice Hooker
[1.3.1.1.1.4.4.3.8.1]
b. 26 Aug 1817 d. 23 Dec 1817
10
Julia Worthington Hooker
[1.3.1.1.1.4.4.3.8.2]
b. 15 Nov 1818 d. 14 Oct 1915
Henry Mason Jones
b. 24 Jul 1811 d. 7 Jul 1886
11
Henry Abbott Jones
[1.3.1.1.1.4.4.3.8.2.1]
b. 29 Mar 1845
11
Charles Armest Jones
[1.3.1.1.1.4.4.3.8.2.2]
b. 25 Feb 1848
+
Emily Cornelia French
b. 26 Mar 1852
11
Frederick Hooker Jones
[1.3.1.1.1.4.4.3.8.2.3]
b. 30 Nov 1866
Alice Mabel Spencer
b. 1873
12
George Frederick Jones
[1.3.1.1.1.4.4.3.8.2.3.1]
b. 18 Apr 1897
10
George Prentice Hooker
[1.3.1.1.1.4.4.3.8.3]
b. 31 May 1820 d. 1912
Lucretia Jane Ashcraft
b. 1822 d. 25 Feb 1897
11
Della Louise Hooker
[1.3.1.1.1.4.4.3.8.3.1]
b. 23 Jul 1844
+
Winchester S Puffer
b. 18 May 1840
11
Augusta R Hooker
[1.3.1.1.1.4.4.3.8.3.2]
b. 12 Oct 1851
Wolfred N Pike
b. 1858
12
George Hooker Pike
[1.3.1.1.1.4.4.3.8.3.2.1]
b. 19 Sep 1885
12
Mabel Josephine Pike
[1.3.1.1.1.4.4.3.8.3.2.2]
b. 24 May 1887
11
George Utley Hooker
[1.3.1.1.1.4.4.3.8.3.3]
b. 9 Oct 1856 d. 13 Jan 1858
11
Cora Jane Hooker
[1.3.1.1.1.4.4.3.8.3.4]
b. 10 Jan 1859
+
Gustave Samuel Smith
10
Charles Gay Hooker
[1.3.1.1.1.4.4.3.8.4]
b. 12 Nov 1822 d. 18 Nov 1905
Maria Celia Osgood
b. 3 Sep 1836
11
Charles Osgood Hooker
[1.3.1.1.1.4.4.3.8.4.1]
b. 10 Aug 1860
Ella Wall Goad
b. 19 Sep 1868 d. 11 Nov 1947
12
Osgood Hooker
[1.3.1.1.1.4.4.3.8.4.1.1]
b. 6 Aug 1897
11
Robert Gay Hooker
[1.3.1.1.1.4.4.3.8.4.2]
b. 13 Jul 1862
11
Jennie May Hooker
[1.3.1.1.1.4.4.3.8.4.3]
b. 3 Jul 1864
11
Bessie Augusta Hooker
[1.3.1.1.1.4.4.3.8.4.4]
b. 31 Dec 1868
11
Florence Gertrude Hooker
[1.3.1.1.1.4.4.3.8.4.5]
b. 1 Apr 1871
10
Ansen Carey Hooker
[1.3.1.1.1.4.4.3.8.5]
b. 2 Sep 1825 d. 4 Jul 1832
10
Henry Clay Hooker
[1.3.1.1.1.4.4.3.8.6]
b. 10 Jan 1828 d. 5 Dec 1907
Elizabeth Tewksbury Rockwell
b. 23 Dec 1837 d. 14 Mar 1915
11
Ida M Hooker
[1.3.1.1.1.4.4.3.8.6.1]
b. 3 May 1858
11
Edwin R Hooker
[1.3.1.1.1.4.4.3.8.6.2]
b. 27 Feb 1861
11
Joseph M Hooker
[1.3.1.1.1.4.4.3.8.6.3]
b. 4 Sep 1863
+
Laura Butler Coffin
b. 1885
10
Almira Ann Hooker
[1.3.1.1.1.4.4.3.8.7]
b. 28 May 1830 d. 5 Jul 1904
Isaiah Hall Nutting
b. 14 Dec 1824 d. 1 Dec 1865
11
Frederic Joseph Nutting
[1.3.1.1.1.4.4.3.8.7.1]
b. 22 Nov 1854
Annie Wheatley
b. 24 Aug 1851
12
Eva Winnefred Nutting
[1.3.1.1.1.4.4.3.8.7.1.1]
b. 7 Nov 1875
12
Minnie Estelle Nutting
[1.3.1.1.1.4.4.3.8.7.1.2]
b. 9 Sep 1878
11
Herbert Hooker Nutting
[1.3.1.1.1.4.4.3.8.7.2]
b. 22 Jul 1859 d. 7 Jul 1947
Loretta Ann McCoy
b. 2 Aug 1860
12
Walter Hull Nutting
[1.3.1.1.1.4.4.3.8.7.2.1]
b. 4 Mar 1886 d. 7 Dec 1931
12
Almira Elizabeth Nutting
[1.3.1.1.1.4.4.3.8.7.2.2]
b. 21 Oct 1888 d. 31 Jan 1956 [
=>
]
12
Clara May Nutting
[1.3.1.1.1.4.4.3.8.7.2.3]
b. 28 Jan 1891 d. 21 Oct 1892
12
Minnie Ber Chambers
[1.3.1.1.1.4.4.3.8.7.2.4]
b. 2 Jun 1892 d. 15 Mar 1973 [
=>
]
11
Minnie Mariah Nutting
[1.3.1.1.1.4.4.3.8.7.3]
b. 4 Aug 1861
10
Minerva Sophia Hooker
[1.3.1.1.1.4.4.3.8.8]
b. 11 Sep 1832 d. 13 Nov 1921
Robert Turnbull Brown
b. 1842 d. 19 Nov 1878
11
Robert Turnbull Brown
[1.3.1.1.1.4.4.3.8.8.1]
b. 31 Jul 1868
11
Minnie Isabel Brown
[1.3.1.1.1.4.4.3.8.8.2]
b. 19 Sep 1871 d. 22 Sep 1871
11
Edith Hooker Brown
[1.3.1.1.1.4.4.3.8.8.3]
b. 1 Jul 1872 d. 15 May 1873
+
Edwin Ruthven Robertson
b. 1828 d. 4 Apr 1902
10
Ansen Carey Hooker
[1.3.1.1.1.4.4.3.8.9]
b. 1 May 1835 d. 8 Nov 1915
10
John Daggett Hooker
[1.3.1.1.1.4.4.3.8.10]
b. 10 May 1838 d. 24 May 1911
Katharine Muzzy Putnam
b. 2 May 1849
11
Laurence Whitney Hooker
[1.3.1.1.1.4.4.3.8.10.1]
b. 14 Jun 1873 d. 11 Dec 1894
11
Marian Osgood Hooker
[1.3.1.1.1.4.4.3.8.10.2]
b. 15 Jul 1875
10
Mary Rosella Hooker
[1.3.1.1.1.4.4.3.8.11]
b. 12 Jan 1841 d. May 1925
+
Nicholas H. Smith
b. 1839
8
Gideon Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.4]
b. 21 Dec 1759 d. 27 Aug 1838
Elizabeth Pratt
b. 22 Jul 1759 d. 1822
9
Gardner Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.4.1]
b. 12 Oct 1788 d. Oct 1843
Eunice White
b. 23 Oct 1787 d. 15 Jun 1833
10
Sophronia Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.4.1.1]
b. 15 Jul 1812 d. 14 Oct 1888
+
Amos Stoddard
10
Diana Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.4.1.2]
b. Dec 1814 d. 1866
10
Eunice Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.4.1.3]
b. Dec 1816 d. 1841
10
Elizabeth Ann Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.4.1.4]
b. 4 Jul 1818
10
William Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.4.1.5]
b. 1821 d. May 1835
10
Gardner Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.4.1.6]
b. Abt 1823
10
Arthur Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.4.1.7]
b. Abt 1825
10
Harriet Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.4.1.8]
b. Apr 1827 d. Oct 1876
Hays G. Luce
b. 1818
11
Emma Melissa Luce
[1.3.1.1.1.4.4.4.1.8.1]
b. Abt 1849
11
Sarah Luce
[1.3.1.1.1.4.4.4.1.8.2]
b. Abt 1851
11
Harriet Luce
[1.3.1.1.1.4.4.4.1.8.3]
b. Abt 1853
11
John Luce
[1.3.1.1.1.4.4.4.1.8.4]
b. 18 May 1854 d. 4 Feb 1922
Mary Hayes
b. 1854 d. 1942
12
Leanora May Luce
[1.3.1.1.1.4.4.4.1.8.4.1]
b. 5 Apr 1878
12
Orrin Oscar Luce
[1.3.1.1.1.4.4.4.1.8.4.2]
b. 15 Mar 1880
11
Moses Luce
[1.3.1.1.1.4.4.4.1.8.5]
b. Abt 1857
11
Emily Luce
[1.3.1.1.1.4.4.4.1.8.6]
b. Abt 1859
10
Ester Smith Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.4.1.9]
b. 27 Sep 1829
Edward Henry Gleason
b. 12 Dec 1823 d. 24 Nov 1889
11
Rollin Henry Gleason
[1.3.1.1.1.4.4.4.1.9.1]
b. 24 Dec 1854 d. 28 Sep 1918
Lura Bell Lease
b. 26 Mar 1857 d. Apr 1921
12
Gertrude Gleason
[1.3.1.1.1.4.4.4.1.9.1.1]
b. 18 Sep 1880
12
Grace Gleason
[1.3.1.1.1.4.4.4.1.9.1.2]
b. 8 Jun 1883 d. 8 Aug 1952 [
=>
]
12
Lura Gleason
[1.3.1.1.1.4.4.4.1.9.1.3]
b. 16 May 1885 d. 4 Aug 1941
12
Ruth Gleason
[1.3.1.1.1.4.4.4.1.9.1.4]
b. 17 Feb 1887 d. 31 Oct 1952
12
Esther Gleason
[1.3.1.1.1.4.4.4.1.9.1.5]
b. 19 May 1889
12
Rollin Gleason
[1.3.1.1.1.4.4.4.1.9.1.6]
b. 4 May 1892 d. Jan 1928
11
Irene May Gleason
[1.3.1.1.1.4.4.4.1.9.2]
b. 3 Feb 1858 d. 24 Feb 1858
11
Emie Bell Gleason
[1.3.1.1.1.4.4.4.1.9.3]
b. 10 May 1860 d. 1 Apr 1886
11
Stanley Gleason
[1.3.1.1.1.4.4.4.1.9.4]
b. 31 Jan 1863 d. 30 Mar 1863
11
Adrienna Gleason
[1.3.1.1.1.4.4.4.1.9.5]
b. 1 May 1864
11
Grace Gleason
[1.3.1.1.1.4.4.4.1.9.6]
b. 8 Oct 1866 d. 12 Aug 1868
11
Helen Gleason
[1.3.1.1.1.4.4.4.1.9.7]
b. 13 Nov 1869 d. 30 Jun 1883
11
Maud Gleason
[1.3.1.1.1.4.4.4.1.9.8]
b. 28 Feb 1873 d. 11 Aug 1874
11
Claud Gleason
[1.3.1.1.1.4.4.4.1.9.9]
b. 28 Feb 1873
10
Rollin Mallory Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.4.1.10]
b. 22 Feb 1831
+
Maggie Curry
b. 19 Mar 1851 d. 21 Mar 1877
+
Lizzie Mabel Hinds
b. 12 Apr 1863
9
William King Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.4.2]
b. 24 Aug 1792 d. 6 Feb 1862
+
Betsy Johnson
b. 20 Sep 1791 d. 6 Nov 1835
9
Nancy Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.4.3]
b. 1793
9
Harvey Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.4.4]
b. 1797
9
Gideon Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.4.5]
b. 1800
8
Betty Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.5]
b. 3 Feb 1763 d. 28 Jul 1829
Thomas Todd
b. 17 Nov 1760 d. 20 Nov 1848
9
Billy Todd
[1.3.1.1.1.4.4.5.1]
b. 15 Jul 1783 d. 1871
9
Lavina Todd
[1.3.1.1.1.4.4.5.2]
b. 1 Sep 1785 d. Mar 1835
9
Orinda Todd
[1.3.1.1.1.4.4.5.3]
b. 1 Sep 1787 d. 12 Jun 1872
Jeremiah Dewey
b. 31 Jan 1788 d. 29 Jul 1849
10
Harvey Dewey
[1.3.1.1.1.4.4.5.3.1]
b. 1814
10
Elizabeth "Betsey" Dewey
[1.3.1.1.1.4.4.5.3.2]
b. 6 Apr 1814 d. 6 Apr 1848
William Van Benschoten
b. 28 Dec 1806 d. 1 Dec 1863
11
Eulalia Carlin Van Benschoten
[1.3.1.1.1.4.4.5.3.2.1]
b. 9 Feb 1834 d. 9 Jul 1898
John Decatur Peterson
b. 26 Feb 1841 d. 27 May 1910
12
Carlin Eulalia Peterson
[1.3.1.1.1.4.4.5.3.2.1.1]
b. 23 Oct 1864 d. 28 May 1951 [
=>
]
12
William John Petersen
[1.3.1.1.1.4.4.5.3.2.1.2]
b. 6 Nov 1866 d. 6 Sep 1886
12
Eva Restoria Petersen
[1.3.1.1.1.4.4.5.3.2.1.3]
b. 12 Mar 1870 d. 29 Apr 1871
12
Betsy Anna Peterson
[1.3.1.1.1.4.4.5.3.2.1.4]
b. 12 Sep 1871 d. 21 Mar 1939 [
=>
]
12
Jane Van Benschoten "Jennie" Petersen
[1.3.1.1.1.4.4.5.3.2.1.5]
b. 3 May 1873 d. 14 Sep 1935 [
=>
]
12
Hiram Dewey Peterson
[1.3.1.1.1.4.4.5.3.2.1.6]
b. 1 Jan 1876 d. 19 Aug 1923 [
=>
]
12
Walter Lee Petersen
[1.3.1.1.1.4.4.5.3.2.1.7]
b. 6 Jul 1878 d. 8 Jul 1878
11
William W Van Benschoten
[1.3.1.1.1.4.4.5.3.2.2]
b. 12 Mar 1836 d. 15 Sep 1837
11
Marion E Van Benschoten
[1.3.1.1.1.4.4.5.3.2.3]
b. 14 Oct 1839 d. 25 Jul 1849
11
Helen Marr Van Benschoten
[1.3.1.1.1.4.4.5.3.2.4]
b. 28 Feb 1841 d. 26 Jul 1849
11
Frank Van Benschoten
[1.3.1.1.1.4.4.5.3.2.5]
b. 17 Jul 1844 d. 20 Sep 1847
11
Elizabeth A Van Benschoten
[1.3.1.1.1.4.4.5.3.2.6]
b. 24 Jan 1846 d. 8 Sep 1846
11
Elmore T Van Benschoten
[1.3.1.1.1.4.4.5.3.2.7]
b. 21 Jul 1847 d. Abt 1848
10
Hiram T Dewey
[1.3.1.1.1.4.4.5.3.3]
b. 13 Jul 1816 d. 25 May 1898
Susan Lanfley Stapleford
b. 28 Dec 1818 d. 25 May 1898
11
Jeremiah Todd Dewey
[1.3.1.1.1.4.4.5.3.3.1]
b. 7 Sep 1841
Laura Zaphia Henderson
12
George Lincoln Dewey
[1.3.1.1.1.4.4.5.3.3.1.1]
b. 8 Mar 1866 d. 20 Mar 1928 [
=>
]
12
Frank H Dewey
[1.3.1.1.1.4.4.5.3.3.1.2]
b. Abt 1868 d. Bef 1880
12
Ella May Dewey
[1.3.1.1.1.4.4.5.3.3.1.3]
b. Abt 1871
11
George Eugene Dewey
[1.3.1.1.1.4.4.5.3.3.2]
b. 19 Dec 1843
Frances Amelia Cameron
b. 28 Jan 1852 d. 6 Mar 1889
12
William Hiram Dewey
[1.3.1.1.1.4.4.5.3.3.2.1]
b. 7 Mar 1886 d. 13 Dec 1951 [
=>
]
12
George Francis Dewey
[1.3.1.1.1.4.4.5.3.3.2.2]
b. 11 Jul 1877
12
Ralph Cameron Dewey
[1.3.1.1.1.4.4.5.3.3.2.3]
b. 18 Nov 1880
12
Julia Loise Dewey
[1.3.1.1.1.4.4.5.3.3.2.4]
b. 27 Oct 1884
11
Mary Elizabeth Dewey
[1.3.1.1.1.4.4.5.3.3.3]
b. 17 Mar 1846
Warren H Doolittle
12
May Doolittle
[1.3.1.1.1.4.4.5.3.3.3.1]
b. Abt 1873
12
Lillian Doolittle
[1.3.1.1.1.4.4.5.3.3.3.2]
b. Abt 1874
12
Harry Doolittle
[1.3.1.1.1.4.4.5.3.3.3.3]
b. Abt 1876
11
Susan Arabella Dewey
[1.3.1.1.1.4.4.5.3.3.4]
b. 26 Jul 1848
William Douglas Ainslie
12
Cora Ainslie
[1.3.1.1.1.4.4.5.3.3.4.1]
b. Abt 1870
12
Lola Ainslie
[1.3.1.1.1.4.4.5.3.3.4.2]
b. Abt 1873
12
Ned Ainslie
[1.3.1.1.1.4.4.5.3.3.4.3]
b. Abt 1875
12
Susan Ainslie
[1.3.1.1.1.4.4.5.3.3.4.4]
b. 21 Sep 1879
12
Hiram Dewey Ainslie
[1.3.1.1.1.4.4.5.3.3.4.5]
b. 3 Nov 1882 [
=>
]
11
Hiram Stapleford Dewey
[1.3.1.1.1.4.4.5.3.3.5]
b. 3 Jul 1857 bur. 12 May 1934
Sophia Matilda Bradford
b. 1 Nov 1856
12
Seth Bradford "Brad" Dewey
[1.3.1.1.1.4.4.5.3.3.5.1]
b. 28 Feb 1882 d. 26 Aug 1938 [
=>
]
12
Hiram Todd Dewey
[1.3.1.1.1.4.4.5.3.3.5.2]
b. 12 Mar 1884 d. 20 Jun 1884
11
William Henry Dewey
[1.3.1.1.1.4.4.5.3.3.6]
b. 1 Jan 1863 d. Dec
+
Harriet C Booth
10
Washington Dewey
[1.3.1.1.1.4.4.5.3.4]
b. 10 Sep 1818 d. 16 Mar 1896
Alvina Webster
b. 23 May 1818 d. 22 Oct 1871
11
Rosa M Dewey
[1.3.1.1.1.4.4.5.3.4.1]
b. Abt 1844
George W Jones
b. Abt 1839
12
George Jones
[1.3.1.1.1.4.4.5.3.4.1.1]
b. Abt 1867
12
Irving P Jones
[1.3.1.1.1.4.4.5.3.4.1.2]
b. Abt 1870
12
Rosa M Jones
[1.3.1.1.1.4.4.5.3.4.1.3]
b. Abt 1877
11
Royal E Dewey
[1.3.1.1.1.4.4.5.3.4.2]
b. 25 Aug 1849 d. 27 Dec 1907
Mary Pride
b. 1855
12
Edward Dewey
[1.3.1.1.1.4.4.5.3.4.2.1]
b. Abt 1874
12
Mabel Dewey
[1.3.1.1.1.4.4.5.3.4.2.2]
b. Abt 1876
11
George Washington Dewey
[1.3.1.1.1.4.4.5.3.4.3]
b. Abt 1853
11
Kate L Dewey
[1.3.1.1.1.4.4.5.3.4.4]
b. Abt 1856
10
Royal Dewey
[1.3.1.1.1.4.4.5.3.5]
b. 1820
10
Orinda Dewey
[1.3.1.1.1.4.4.5.3.6]
b. 1822
9
Diantha Todd
[1.3.1.1.1.4.4.5.4]
b. 1 May 1791 d. 27 Dec 1824
9
Elmer Todd
[1.3.1.1.1.4.4.5.5]
b. 16 Jun 1793 d. 13 Oct 1812
9
Relief Todd
[1.3.1.1.1.4.4.5.6]
b. 11 Mar 1798 d. 19 Oct 1885
Joseph Moulton
b. 7 Feb 1798 d. 10 Feb 1873
10
Anne Moulton
[1.3.1.1.1.4.4.5.6.1]
b. 31 Mar 1822
Charles Cowles
b. 19 Dec 1817 d. 28 Feb 1869
11
Joseph Moulton Cowles
[1.3.1.1.1.4.4.5.6.1.1]
b. 30 Jul 1848 d. 31 Dec 1850
11
Harriet Anne Cowles
[1.3.1.1.1.4.4.5.6.1.2]
b. 1 Sep 1850
11
Martha Chase Cowles
[1.3.1.1.1.4.4.5.6.1.3]
b. 3 Nov 1852
11
Chester William Cowles
[1.3.1.1.1.4.4.5.6.1.4]
b. 7 Dec 1854 d. 7 May 1858
11
Charlotte Cowles
[1.3.1.1.1.4.4.5.6.1.5]
b. 27 Jan 1859
William Henry Ober
b. 1857 d. 2 Mar 1885
12
Mildred Ruth Ober
[1.3.1.1.1.4.4.5.6.1.5.1]
b. 14 Sep 1883 d. 25 Apr 1895
11
Charles Albert Cowles
[1.3.1.1.1.4.4.5.6.1.6]
b. 12 May 1862
Lettie Estelle Ford
b. 28 Apr 1861
12
Charles Leon Cowles
[1.3.1.1.1.4.4.5.6.1.6.1]
b. 31 Jan 1891
10
James Thompson Moulton
[1.3.1.1.1.4.4.5.6.2]
b. 1 Nov 1823
Louisa J Williams
b. 28 Dec 1822 d. 12 Apr 1871
11
Catherine Elizabeth Moulton
[1.3.1.1.1.4.4.5.6.2.1]
b. 26 Jan 1852
11
Joseph Moulton
[1.3.1.1.1.4.4.5.6.2.2]
b. 5 Feb 1854
Emma Gertrude Addie Pool
b. 4 Nov 1862
12
Louise Margaret Moulton
[1.3.1.1.1.4.4.5.6.2.2.1]
b. 13 Mar 1889
11
David W Moulton
[1.3.1.1.1.4.4.5.6.2.3]
b. 9 Nov 1855 d. 27 Jun 1937
+
Marceline L Bunton
b. 2 Sep 1860
11
Abbie Louisa Moulton
[1.3.1.1.1.4.4.5.6.2.4]
b. 1 May 1857
11
James Thompson Moulton
[1.3.1.1.1.4.4.5.6.2.5]
b. 18 Mar 1859 d. 10 Jul 1859
11
Anna Moulton
[1.3.1.1.1.4.4.5.6.2.6]
b. 10 Apr 1860 d. 13 May 1862
11
Annette Frances Moulton
[1.3.1.1.1.4.4.5.6.2.7]
b. 21 Nov 1862
11
John Franklin Moulton
[1.3.1.1.1.4.4.5.6.2.8]
b. 1 Jan 1866 d. 15 Aug 1894
+
Helen Ewell
b. 20 Jul 1822 d. 27 Jan 1909
10
Charles Henry Moulton
[1.3.1.1.1.4.4.5.6.3]
b. 6 Feb 1829
Lydia S Wiley
b. Abt 1830
11
Mary Ellen Moulton
[1.3.1.1.1.4.4.5.6.3.1]
b. 20 Apr 1856
10
John Todd Moulton
[1.3.1.1.1.4.4.5.6.4]
b. 7 Aug 1838 d. 10 Feb 1873
Sarah Frances Sweetser
b. 20 Jun 1841 d. 24 Apr 1918
11
Annie Coules Moulton
[1.3.1.1.1.4.4.5.6.4.1]
b. 5 Dec 1867
Charles E Haywood
b. Oct 1868 d. Dec 1972
12
Richard Mansfield Haywood
[1.3.1.1.1.4.4.5.6.4.1.1]
b. 1905
12
Henry Stewart Haywood
[1.3.1.1.1.4.4.5.6.4.1.2]
b. 29 Dec 1906 d. Aug 1977
11
Albert S Moulton
[1.3.1.1.1.4.4.5.6.4.2]
b. 31 Jul 1872 d. 15 Sep 1943
Grace E Lufkin
b. 1 Jan 1882 d. 14 Mar 1928
12
Robert Lufkin Moulton
[1.3.1.1.1.4.4.5.6.4.2.1]
b. 7 Mar 1909 d. 18 Sep 1949
11
Robert Elmer Moulton
[1.3.1.1.1.4.4.5.6.4.3]
b. 15 Jan 1876 d. 3 Sep 1876
11
Elizabeth Jane Moulton
[1.3.1.1.1.4.4.5.6.4.4]
b. 28 Aug 1878
+
Thomas C Christie
11
Bessie Jane Moulton
[1.3.1.1.1.4.4.5.6.4.5]
b. 28 Aug 1878
10
Walter Scott Moulton
[1.3.1.1.1.4.4.5.6.5]
b. 9 Aug 1840 d. 17 Jun 1874
Rosalinda E. Wilson
b. May 1848
11
Relief Esther Moulton
[1.3.1.1.1.4.4.5.6.5.1]
b. 14 Jun 1868
Everett H Day
b. Feb 1870
12
Rosalinda Ellen Day
[1.3.1.1.1.4.4.5.6.5.1.1]
b. 11 Mar 1892 d. 16 Mar 1978 [
=>
]
12
Earl M Day
[1.3.1.1.1.4.4.5.6.5.1.2]
b. Oct 1894
12
Maurice Herman Day
[1.3.1.1.1.4.4.5.6.5.1.3]
b. 3 Dec 1896
9
Alanson Todd
[1.3.1.1.1.4.4.5.7]
b. 5 Sep 1800 d. 13 Jul 1882
Lydia Wheeler
b. 24 Oct 1800 d. 14 Oct 1877
10
Elmor Todd
[1.3.1.1.1.4.4.5.7.1]
b. 27 Feb 1828 d. 16 Jul 1829
10
Son Todd
[1.3.1.1.1.4.4.5.7.2]
b. 4 Jul 1829 d. 4 Jul 1829
10
Cornelia Todd
[1.3.1.1.1.4.4.5.7.3]
b. 15 May 1831 d. 14 Mar 1877
+
Julius Leonard Stacey
b. 16 Oct 1826 d. 7 Nov 1902
10
Cyrus Wheeler Todd
[1.3.1.1.1.4.4.5.7.4]
b. 5 Jun 1833 d. 25 Dec 1903
Louisa Charlotte Hoese
d. 8 Mar 1926
11
William Irving Todd
[1.3.1.1.1.4.4.5.7.4.1]
b. 25 Aug 1873 d. 1 Dec 1942
+
Effie Gertrude Townsend
b. 30 Mar 1878 d. 28 Jan 1948
11
Helen May Todd
[1.3.1.1.1.4.4.5.7.4.2]
b. 3 May 1875
Ralph J Olson
b. Oct 1873
12
Thelma Lucille Olson
[1.3.1.1.1.4.4.5.7.4.2.1]
b. 21 Oct 1898
12
Plin Gifford Olson
[1.3.1.1.1.4.4.5.7.4.2.2]
b. 31 Aug 1900
12
Clara Frances Olson
[1.3.1.1.1.4.4.5.7.4.2.3]
b. 25 Dec 1901
12
Everett Clare "Lerch" Olson
[1.3.1.1.1.4.4.5.7.4.2.4]
b. 10 Feb 1907 d. 1942
+
Harry Raymond Trosper
b. 6 Jan 1884 d. 16 Dec 1926
11
Frank Hyrum Todd
[1.3.1.1.1.4.4.5.7.4.3]
b. 10 Sep 1883 d. 28 Jun 1958
Nellie Edith Farnham
b. 8 May 1889 d. 1 Aug 1978
12
Dr Frank Arnold Todd, DVM
[1.3.1.1.1.4.4.5.7.4.3.1]
b. 11 Sep 1911 d. 26 Feb 1995 [
=>
]
12
Guy Harold Todd
[1.3.1.1.1.4.4.5.7.4.3.2]
b. 11 Sep 1911 d. 18 Jan 1966
12
Helen Louise Todd
[1.3.1.1.1.4.4.5.7.4.3.3]
b. 8 May 1923 d. 10 Sep 1972
12
Gene William Todd
[1.3.1.1.1.4.4.5.7.4.3.4]
b. 28 Nov 1926 d. 10 Jan 1931
10
Hiram Todd
[1.3.1.1.1.4.4.5.7.5]
b. 30 Apr 1836 d. 20 Jun 1840
10
Helen Mar Todd
[1.3.1.1.1.4.4.5.7.6]
b. 1 Jul 1838 d. 27 Jan 1923
9
Charles Todd
[1.3.1.1.1.4.4.5.8]
b. 27 Sep 1802 d. 8 Apr 1804
9
Hiram Todd
[1.3.1.1.1.4.4.5.9]
b. 18 Nov 1795 d. 11 Jul 1849
Lydia Church
b. 8 Jan 1802 d. 26 Dec 1871
10
Caroline Todd
[1.3.1.1.1.4.4.5.9.1]
b. 26 Feb 1830 d. Mar 1833
10
Frances Todd
[1.3.1.1.1.4.4.5.9.2]
b. 12 Sep 1832
Rodney S Bowen
b. 1831 d. 3 Dec 1864
11
Mary C Bowen
[1.3.1.1.1.4.4.5.9.2.1]
b. Abt 1852
11
Rodney S Bowen
[1.3.1.1.1.4.4.5.9.2.2]
b. Abt 1854
11
Albert W Bowen
[1.3.1.1.1.4.4.5.9.2.3]
b. Abt 1856
11
Martha Bowen
[1.3.1.1.1.4.4.5.9.2.4]
b. Abt 1858
10
Hiram Church Todd
[1.3.1.1.1.4.4.5.9.3]
b. 26 Jun 1835
Sarah D Barnard
b. 2 Jan 1842 d. 2 Oct 1878
11
Maggie Barnard Todd
[1.3.1.1.1.4.4.5.9.3.1]
b. 21 Nov 1862 d. 25 Aug 1881
11
Walter Wilson Todd
[1.3.1.1.1.4.4.5.9.3.2]
b. 22 May 1865
Fannie Taylor Clarke
b. Abt 1869
12
Dorothy Clarke Todd
[1.3.1.1.1.4.4.5.9.3.2.1]
b. 17 Mar 1894
12
Thomas C Todd
[1.3.1.1.1.4.4.5.9.3.2.2]
b. 6 Oct 1897
11
Grace Lydia Todd
[1.3.1.1.1.4.4.5.9.3.3]
b. 18 Oct 1868 d. 30 Mar 1872
11
Lucia May Todd
[1.3.1.1.1.4.4.5.9.3.4]
b. 4 May 1873 d. 11 Mar 1874
11
Lillian Belle Todd
[1.3.1.1.1.4.4.5.9.3.5]
b. 8 Dec 1874 d. 7 Aug 1876
11
Frank Ransom Todd
[1.3.1.1.1.4.4.5.9.3.6]
b. 1 Mar 1877 d. 27 Sep 1877
10
Martha Todd
[1.3.1.1.1.4.4.5.9.4]
b. 21 Sep 1837 d. 1 Sep 1847
10
Walter Wilson Todd
[1.3.1.1.1.4.4.5.9.5]
b. 27 Feb 1840 d. 18 Oct 1899
Azenath M Gerard
b. 9 Nov 1844 d. 16 Dec 1895
11
Laura Todd
[1.3.1.1.1.4.4.5.9.5.1]
b. 4 Oct 1869
+
Webb Wilde Martin
b. 10 Jan 1872
11
Church Gerard Todd
[1.3.1.1.1.4.4.5.9.5.2]
b. 15 Jan 1871
+
Zaide Murphy
b. 1 Jan 1874
11
Hiram Eugene Todd
[1.3.1.1.1.4.4.5.9.5.3]
b. 10 Sep 1874
+
Bertha May Ferris
b. May 1878
10
Edgar Todd
[1.3.1.1.1.4.4.5.9.6]
b. Abt 1842
9
Solomon Todd
[1.3.1.1.1.4.4.5.10]
b. 15 Oct 1804 d. 17 Oct 1832
9
Betsey Todd
[1.3.1.1.1.4.4.5.11]
b. 8 Nov 1806
Austin Bruce
b. 19 Dec 1803
10
Frances Elizabeth Bruce
[1.3.1.1.1.4.4.5.11.1]
b. 6 Sep 1830 d. 27 Sep 1915
Boardman F Stafford
b. 23 Apr 1827 d. 21 Oct 1886
11
Christopher Boardman Stafford
[1.3.1.1.1.4.4.5.11.1.1]
b. Oct 1856 d. 1925
Emma Hulda Hopkins
b. 20 Sep 1855 d. 24 May 1924
12
Earl Christopher Stafford
[1.3.1.1.1.4.4.5.11.1.1.1]
b. 19 Sep 1892 d. 22 Apr 1960 [
=>
]
11
Dwight Bliss Stafford
[1.3.1.1.1.4.4.5.11.1.2]
b. 11 Jan 1860 d. 1936
+
Esther P Cobb
b. 28 Feb 1863
11
Palmer A Stafford
[1.3.1.1.1.4.4.5.11.1.3]
b. 1 Jun 1869
8
Tamar Daggett
[1.3.1.1.1.4.4.6]
b. 24 Mar 1767 d. 23 Oct 1820
Eliphalet Holman
b. Abt 1761 d. 30 May 1838
9
Catharine Holman
[1.3.1.1.1.4.4.6.1]
b. 3 Dec 1789 d. 11 Aug 1864
John Cummings
b. 2 May 1786 d. 30 Oct 1832
10
Lucy Daggett Cummings
[1.3.1.1.1.4.4.6.1.1]
b. 18 Feb 1808 d. 9 Apr 1818
10
Tamar Holman Cummings
[1.3.1.1.1.4.4.6.1.2]
b. 19 Sep 1810 d. 5 Nov 1830
10
Eliphalet H Cummings
[1.3.1.1.1.4.4.6.1.3]
b. 2 Dec 1813 d. 15 Nov 1875
Harriet Aldrich
b. 12 Jun 1822 d. 15 Dec 1852
11
Cordelia Ann Cummings
[1.3.1.1.1.4.4.6.1.3.1]
b. 15 Dec 1841 d. 15 Jan 1856
11
George Francis "Franklin" Cummings
[1.3.1.1.1.4.4.6.1.3.2]
b. 27 Sep 1842 d. 30 Mar 1891
Julia Maria Hopkins
b. 16 Jan 1840 d. 28 Feb 1888
12
Harriet Gould Cummings
[1.3.1.1.1.4.4.6.1.3.2.1]
b. 10 Jan 1869 d. Abt 1940
12
Mary Elizabeth Cummings
[1.3.1.1.1.4.4.6.1.3.2.2]
b. 8 Sep 1875 d. 6 Jun 1878
12
Charles Franklin Cummings
[1.3.1.1.1.4.4.6.1.3.2.3]
b. 28 Dec 1877 d. 29 Jan 1935 [
=>
]
+
Sarah D Cummings
b. Abt 1820
10
Daniel Cummings
[1.3.1.1.1.4.4.6.1.4]
b. 15 May 1816 d. 15 Nov 1875
10
Preston Cummings
[1.3.1.1.1.4.4.6.1.5]
b. 10 Jun 1818 d. 14 Sep 1868
10
Lucy Cummings
[1.3.1.1.1.4.4.6.1.6]
b. 10 Oct 1819 d. 27 Sep 1821
10
Catharine Cummings
[1.3.1.1.1.4.4.6.1.7]
b. 1 Oct 1821 d. 27 Nov 1896
10
Diantha Cummings
[1.3.1.1.1.4.4.6.1.8]
b. 29 Mar 1823 d. 21 Sep 1860
10
John Cummings
[1.3.1.1.1.4.4.6.1.9]
b. 25 Dec 1824 d. 20 Jul 1898
10
Mary Cummings
[1.3.1.1.1.4.4.6.1.10]
b. 22 Jul 1827 d. 1904
10
Candace H Cummings
[1.3.1.1.1.4.4.6.1.11]
b. 1829
10
Lucy Tamar Cummings
[1.3.1.1.1.4.4.6.1.12]
b. 16 Oct 1831 d. 30 Sep 1833
6
Samuel Sibley
[1.3.1.1.1.5]
b. 16 May 1697 d. Dec 1730
Martha Dike
b. Abt 1700 d. 5 Oct 1775
7
Samuel Sibley
[1.3.1.1.1.5.1]
b. 1724 d. 31 Aug 1801
7
Nathaniel Sibley
[1.3.1.1.1.5.2]
b. Abt 1725 d. 24 May 1811
Ruth Bradish
b. 7 May 1722 d. 12 Aug 1810
8
Ruth Sibley
[1.3.1.1.1.5.2.1]
b. 9 Apr 1745 d. 30 Nov 1814
Benoni Benson
b. 11 Jul 1747 d. 1803
9
John Benson
[1.3.1.1.1.5.2.1.1]
b. 1789
8
Martha Sibley
[1.3.1.1.1.5.2.2]
b. 17 Apr 1747 d. 4 Mar 1775
8
Mary Sibley
[1.3.1.1.1.5.2.3]
b. 1 Sep 1749
8
Eunice Sibley
[1.3.1.1.1.5.2.4]
b. 27 Feb 1752 d. Mar 1775
8
Nathan Sibley
[1.3.1.1.1.5.2.5]
b. 22 Jun 1754 d. 22 Feb 1755
8
Stephen Sibley
[1.3.1.1.1.5.2.6]
b. 21 Sep 1756
8
Nathaniel Sibley
[1.3.1.1.1.5.2.7]
b. 20 Apr 1759 d. 25 Aug 1775
8
Jonas Sibley
[1.3.1.1.1.5.2.8]
b. 7 Mar 1762 d. 5 Feb 1834
7
Lucy Sibley
[1.3.1.1.1.5.3]
b. 16 Apr 1726 d. 13 Dec 1821
7
Jeremiah Sibley
[1.3.1.1.1.5.4]
b. 31 Dec 1728 d. Abt 1807
7
Benjamin Sibley
[1.3.1.1.1.5.5]
b. 27 Feb 1731 d. Aft 27 Jan 1794
6
William Sibley
[1.3.1.1.1.6]
c. 7 Sep 1700 d. 18 Sep 1763
Sarah
b. Abt 1703
7
William Sibley
[1.3.1.1.1.6.1]
b. 4 May 1727
7
Elijah Sibley
[1.3.1.1.1.6.2]
b. Abt 1728
7
Sarah Sibley
[1.3.1.1.1.6.3]
b. 23 Aug 1730 d. 13 Jun 1816
7
Daniel Sibley
[1.3.1.1.1.6.4]
b. 31 Jan 1732
7
David Sibley
[1.3.1.1.1.6.5]
b. 3 Oct 1736
6
Benjamin Sibley
[1.3.1.1.1.7]
b. 19 Sep 1703 d. 2 Nov 1780
Pricilla Rich
b. 28 Sep 1706 d. 1 Feb 1782
7
Priscilla Sibley
[1.3.1.1.1.7.1]
b. 5 Aug 1725 d. 6 Feb 1737
7
Benjamin Sibley, Jr
[1.3.1.1.1.7.2]
b. 17 Aug 1727 d. 12 Nov 1789
7
Zuruiah Sibley
[1.3.1.1.1.7.3]
b. 31 Aug 1729 d. Aft 1770
7
Susanna Sibley
[1.3.1.1.1.7.4]
b. 31 Aug 1733 d. 24 Apr 1810
7
Ezra Sibley
[1.3.1.1.1.7.5]
b. 4 Aug 1738 d. 11 Oct 1762
7
Aaron Sibley
[1.3.1.1.1.7.6]
b. 2 Jul 1740 d. 1776
7
Moses Sibley
[1.3.1.1.1.7.7]
b. 9 May 1743 d. 16 Sep 1760
7
Joseph Sibley
[1.3.1.1.1.7.8]
b. 19 Aug 1745
7
Samuel Sibley
[1.3.1.1.1.7.9]
b. 14 Jun 1747 d. 1841
7
Jonathan Sibley
[1.3.1.1.1.7.10]
b. 4 Mar 1750 d. 31 Jul 1828
4
Elizabeth Black
[1.3.1.2]
b. Abt 1632
Sir Humphrey Gilbert
b. 1616 d. Bef 30 Mar 1658
5
Martha Gilbert
[1.3.1.2.1]
b. Abt 1651 d. Bef 4 Feb 1692
5
Abigail Gilbert
[1.3.1.2.2]
b. Abt 1654 d. 1735
5
Esther Gilbert
[1.3.1.2.3]
b. 1654
5
John Gilbert
[1.3.1.2.4]
b. 1656 d. 17 Mar 1722
Elizabeth Kilham
b. 1657 d. 17 Mar 1722
6
Mary Gilbert
[1.3.1.2.4.1]
b. Abt 1681 d. 1681
6
Elizabeth Gilbert
[1.3.1.2.4.2]
b. Abt 1683
6
Daniel Gilbert
[1.3.1.2.4.3]
b. Abt 1685 d. 2 Nov 1723
Elisabeth Porter
b. Abt 1689 d. Jan 1789
7
Lydia Gilbert
[1.3.1.2.4.3.1]
b. 9 Dec 1711 d. Abt 1757
7
Mary Gilbert
[1.3.1.2.4.3.2]
b. 17 Sep 1721 d. 1760
7
Elizabeth Gilbert
[1.3.1.2.4.3.3]
c. 13 Nov 1713 d. 21 Aug 1751
Joseph Noyes
b. 14 Jul 1710 d. 1754
8
Elizabeth Noyes
[1.3.1.2.4.3.3.1]
b. 18 Dec 1735 d. 9 Jul 1829
Thomas Phillips
b. 7 Jun 1747 d. 9 Jul 1829
9
Rhoda Phillips
[1.3.1.2.4.3.3.1.1]
b. Abt 1770 d. 23 Nov 1825
Enoch King
b. 22 Jan 1770 d. 8 Oct 1853
10
Betsy King
[1.3.1.2.4.3.3.1.1.1]
b. 1789 d. 20 Mar 1863
10
Lydia King
[1.3.1.2.4.3.3.1.1.2]
b. Abt 1789 d. 16 May 1835
10
Lucy King
[1.3.1.2.4.3.3.1.1.3]
b. Abt 1789 d. 1790
10
Electa King
[1.3.1.2.4.3.3.1.1.4]
b. Abt 1791 d. Aft 1870
10
Otis King
[1.3.1.2.4.3.3.1.1.5]
b. 15 Mar 1793 d. 20 Mar 1863
10
Rachael King
[1.3.1.2.4.3.3.1.1.6]
b. Abt 1799 d. 1801
10
Polly Mary King
[1.3.1.2.4.3.3.1.1.7]
b. 18 Dec 1799 d. 28 Oct 1881
10
Moses King
[1.3.1.2.4.3.3.1.1.8]
b. 1803 d. 20 Mar 1863
10
Dorcas King
[1.3.1.2.4.3.3.1.1.9]
b. 3 May 1804 d. 6 Oct 1876
10
Thomas Jefferson King
[1.3.1.2.4.3.3.1.1.10]
b. 27 May 1806 d. 23 Sep 1876
Rebecca Englesby Olin
b. 30 Apr 1805 d. 12 Nov 1876
11
George Elisha King
[1.3.1.2.4.3.3.1.1.10.1]
b. 23 Oct 1828 d. 28 Oct 1855
Sabrina Curtis
b. 3 Apr 1829 d. 27 Jun 1890
12
David Abraham King
[1.3.1.2.4.3.3.1.1.10.1.1]
b. 21 Jan 1847 d. 18 Mar 1921 [
=>
]
12
Rebecca Angeline King
[1.3.1.2.4.3.3.1.1.10.1.2]
b. 1849 d. 1849
11
William Jefferson King
[1.3.1.2.4.3.3.1.1.10.2]
b. 13 Jul 1833 d. 26 Jun 1860
11
Jonathan Alma King
[1.3.1.2.4.3.3.1.1.10.3]
b. 2 Feb 1835 d. Dec 1849
11
Amy Jane King
[1.3.1.2.4.3.3.1.1.10.4]
b. 2 Oct 1836 d. 8 Nov 1913
Elias Smith
b. 6 Sep 1804 d. 24 Jun 1888
12
Silas Thomas Smith
[1.3.1.2.4.3.3.1.1.10.4.1]
b. 4 May 1857 d. 1 May 1945
12
Jesse Moroni Smith
[1.3.1.2.4.3.3.1.1.10.4.2]
b. 21 Nov 1858 d. 14 Mar 1937
12
Rebecca Jane Smith
[1.3.1.2.4.3.3.1.1.10.4.3]
b. 23 Sep 1860 d. 18 Jul 1923
12
Mary Alzina Knapp Smith
[1.3.1.2.4.3.3.1.1.10.4.4]
b. 16 May 1865 d. 20 Jan 1953
12
Martha Priscilla Smith
[1.3.1.2.4.3.3.1.1.10.4.5]
b. 30 May 1865 d. 18 Apr 1946
12
Amy Esther Smith
[1.3.1.2.4.3.3.1.1.10.4.6]
b. 11 Aug 1867 d. 21 Sep 1910
12
Angelina Adelia Smith
[1.3.1.2.4.3.3.1.1.10.4.7]
b. 11 Jul 1869 d. 8 Mar 1950
12
Franklin Elias Smith
[1.3.1.2.4.3.3.1.1.10.4.8]
b. 13 Dec 1871 d. 24 Jul 1917
12
Sarah Susannah Smith
[1.3.1.2.4.3.3.1.1.10.4.9]
b. 26 Mar 1873 d. 25 Apr 1952
12
Hiram Bennett Smith
[1.3.1.2.4.3.3.1.1.10.4.10]
b. 2 Feb 1877 d. 29 Mar 1951
11
Rhoda Eleanor King
[1.3.1.2.4.3.3.1.1.10.5]
b. 3 Oct 1839 d. 5 Jul 1840
11
Enoch Elmer King
[1.3.1.2.4.3.3.1.1.10.6]
b. 3 Oct 1839 d. 20 Feb 1850
11
Thomas Franklin King
[1.3.1.2.4.3.3.1.1.10.7]
b. 1 May 1842 d. 8 Jan 1913
11
Rebecca Angelina King
[1.3.1.2.4.3.3.1.1.10.8]
b. 29 Jun 1845 d. 1 Dec 1908
10
Enoch Edwin King
[1.3.1.2.4.3.3.1.1.11]
b. 1808 d. 23 Sep 1886
10
John Russell King
[1.3.1.2.4.3.3.1.1.12]
b. 16 Oct 1810 d. 28 Feb 1877
10
Rhoda King
[1.3.1.2.4.3.3.1.1.13]
b. 1811
9
Mary Phillips
[1.3.1.2.4.3.3.1.2]
b. 1 Oct 1774 d. 20 Apr 1844
9
Rachael Phillips
[1.3.1.2.4.3.3.1.3]
b. 1777 d. 9 Mar 1864
9
Russel Phillips
[1.3.1.2.4.3.3.1.4]
b. 31 Aug 1785 d. 15 Apr 1856
9
Caleb Phillips
[1.3.1.2.4.3.3.1.5]
b. Abt 1787
9
Moses Phillips
[1.3.1.2.4.3.3.1.6]
b. Abt 1789
9
Betsey Phillips
[1.3.1.2.4.3.3.1.7]
b. 1789 d. 1813
9
Dorcas Phillips
[1.3.1.2.4.3.3.1.8]
b. Abt 1789
8
Mary Noyes
[1.3.1.2.4.3.3.2]
b. 28 Dec 1737
8
Daniel Noyes
[1.3.1.2.4.3.3.3]
b. 10 Jun 1740 d. Abt 1824
8
Moses Noyes
[1.3.1.2.4.3.3.4]
b. 11 May 1743
7
Mercy Gilbert
[1.3.1.2.4.3.4]
c. 1 Apr 1716
7
Daniel Gilbert
[1.3.1.2.4.3.5]
c. 13 Apr 1718
7
Hannah Gilbert
[1.3.1.2.4.3.6]
c. 23 Dec 1722
6
Martha Gilbert
[1.3.1.2.4.4]
b. Abt 1688
6
Benjamin Gilbert
[1.3.1.2.4.5]
b. 1 Feb 1691 d. 24 Jun 1760
6
Joseph Gilbert
[1.3.1.2.4.6]
b. 1 Feb 1691 d. Mar 1763
6
Noah Gilbert
[1.3.1.2.4.7]
b. 21 Nov 1703 d. 22 Nov 1768
4
Lydia Black
[1.3.1.3]
b. 25 Dec 1636
4
Lydia Black
[1.3.1.4]
b. 3 Jun 1638 d. Bef 1748
4
John Black, Jr
[1.3.1.5]
b. 1642 d. 18 Aug 1700
3
Patrick Black
[1.3.2]
b. 28 Sep 1692