Home Page
|
What's New
|
Photos
|
Histories
|
Headstones
|
Reports
|
Surnames
Search
First Name:
Last Name:
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Suomalainen
Svenska
Alexander Skene
1517 - 1604 (87 years)
Submit Photo / Document
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Submit Photo / Doc
Worksheet
Family
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Alexander Skene
[1]
b. 1517 d. 1604
Elizabeth Forbes
b. 1517
2
James Skeen
[1.1]
b. Abt 1536 d. 1605
2
Agnes Skeen
[1.2]
b. Abt 1537 d. 1693
John Black
b. Abt 1540 d. 1591
3
Alexander Black
[1.2.1]
b. Abt 1559
3
Agnes Black
[1.2.2]
b. Abt 1564
3
John Black
[1.2.3]
b. Abt 1565
Elizabeth Locart
b. 1570 d. 1641
4
John Black
[1.2.3.1]
b. Abt 1613 d. 1 Mar 1675
Susanna Freeman
b. Abt 1610 d. Aft 1645
5
Persis Black
[1.2.3.1.1]
b. Abt 1627 d. 20 Jul 1677
William Follett
b. Abt 1625
6
Susanna Follett
[1.2.3.1.1.1]
b. 1 Jun 1662
Joseph Sibley
b. 1655 d. 25 Apr 1711
7
Joseph Sibley
[1.2.3.1.1.1.1]
b. 9 Nov 1685 d. 1754
Elizabeth Boutwell
b. 2 Mar 1683 d. Bef 1734
8
Joseph Sibley
[1.2.3.1.1.1.1.1]
b. 6 Mar 1709 d. 22 Aug 1777
8
John Sibley
[1.2.3.1.1.1.1.2]
b. 2 Aug 1711 d. 27 Nov 1778
8
James Sibley
[1.2.3.1.1.1.1.3]
b. 7 May 1714
8
Elizabeth Sibley
[1.2.3.1.1.1.1.4]
b. Abt 1716
8
Jonathan Sibley
[1.2.3.1.1.1.1.5]
b. 11 Sep 1718 d. 30 Mar 1787
8
Hannah Sibley
[1.2.3.1.1.1.1.6]
b. 27 Jun 1721
8
Susanna Sibley
[1.2.3.1.1.1.1.7]
b. 24 Aug 1723
8
Mary Sibley
[1.2.3.1.1.1.1.8]
b. 23 Sep 1725
7
John Sibley
[1.2.3.1.1.1.2]
b. 18 Sep 1687 d. 13 May 1741
Zerviah Gould
b. 20 Apr 1694 d. Bef 1741
8
Ebenezer Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.1]
b. 28 Feb 1717 d. 4 Mar 1790
Abigail Cummings
b. 3 May 1716 d. 27 Sep 1783
9
Stephen Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.1.1]
b. 12 Jul 1741 d. 25 Aug 1828
Thankful Taft
b. 25 May 1745 d. 26 Oct 1837
10
Joel Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.1.1.1]
b. 25 Apr 1766 d. 10 Apr 1839
Lois Louise Woods
b. 24 Jun 1767 d. 21 Nov 1832
11
Amory Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.1.1.1.1]
b. 20 Jun 1792 d. 22 Jun 1849
Caroline Bosworth
b. Abt 1796 d. 13 Jan 1858
12
Martha Elmira Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.1.1.1.1.1]
b. 16 Oct 1839 d. 1 Oct 1920 [
=>
]
11
Josiah Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.1.1.1.2]
b. 1 Apr 1808 d. 7 Dec 1888
Sarah Ann Sophia Crapon
b. 24 Oct 1809 d. 17 May 1858
12
Samuel Hale Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.1.1.1.2.1]
b. 9 Sep 1835 d. 1883 [
=>
]
12
William Crapon Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.1.1.1.2.2]
b. 3 May 1832 d. 17 Apr 1902 [
=>
]
12
Henry Josiah Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.1.1.1.2.3]
b. 19 Nov 1833 d. 25 Jul 1864
12
Sophia Matilda Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.1.1.1.2.4]
b. 16 Oct 1837 d. 29 Oct 1897
12
George Royal Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.1.1.1.2.5]
b. 19 Jul 1839 d. 15 Jul 1895 [
=>
]
12
Fannie Maria Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.1.1.1.2.6]
b. 13 Oct 1841 d. 20 Dec 1842
12
Mary Lois Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.1.1.1.2.7]
b. 3 Sep 1843 d. 23 Feb 1864
12
Alice Marie Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.1.1.1.2.8]
b. 9 Feb 1846 d. 13 Jul 1907
12
Robert Pendelton Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.1.1.1.2.9]
b. Abt 1847 [
=>
]
12
Caroline Crapon Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.1.1.1.2.10]
b. 21 Feb 1850 d. 16 Nov 1858
12
Amory Walter Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.1.1.1.2.11]
b. 19 Jun 1852 d. 28 Jul 1899
12
Josiah Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.1.1.1.2.12]
b. 1866 d. 1879
Emaline Eve
b. 1839
12
John Adam Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.1.1.1.2.13]
b. 1 Sep 1861 d. 26 Mar 1934
12
James Longstreet Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.1.1.1.2.14]
b. 4 Aug 1863 d. 10 Sep 1945 [
=>
]
12
Mary Bones Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.1.1.1.2.15]
b. 29 Mar 1865 d. 22 Jun 1954
12
Emma Josephine Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.1.1.1.2.16]
b. 23 Feb 1867 d. 25 Oct 1957 [
=>
]
10
Lydia Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.1.1.2]
b. 2 Apr 1769 d. 27 Nov 1822
Henry Staples Benson
b. 8 Aug 1770 d. 29 Jul 1821
11
Abigail Benson
[1.2.3.1.1.1.2.1.1.2.1]
b. 31 Mar 1795 d. 10 Nov 1821
Asa Legg
b. 7 May 1792 d. 15 Nov 1836
12
Charlotte Legg
[1.2.3.1.1.1.2.1.1.2.1.1]
b. 2 May 1818 d. 30 Oct 1900 [
=>
]
12
Lyman Legg
[1.2.3.1.1.1.2.1.1.2.1.2]
b. 3 Sep 1822 d. 1 Sep 1904 [
=>
]
11
Harriet Benson
[1.2.3.1.1.1.2.1.1.2.2]
b. 14 Sep 1796 d. 22 Aug 1852
11
Mellen Benson
[1.2.3.1.1.1.2.1.1.2.3]
b. 14 Jan 1798
Eliza W Farnum
b. 25 Sep 1802 d. 14 Sep 1839
12
Henry Staples Benson
[1.2.3.1.1.1.2.1.1.2.3.1]
b. 17 May 1829
12
Almira Farnum Benson
[1.2.3.1.1.1.2.1.1.2.3.2]
b. 6 Aug 1830 d. 25 Dec 1835
12
James Haskins Benson
[1.2.3.1.1.1.2.1.1.2.3.3]
b. 16 Oct 1833
12
George Everett Benson
[1.2.3.1.1.1.2.1.1.2.3.4]
b. 14 Aug 1837
+
Mary Windsor Peck
b. 21 May 1798
11
Hannah Adaline Benson
[1.2.3.1.1.1.2.1.1.2.4]
b. 12 Aug 1802 d. 19 Jun 1822
11
Rufus Benson
[1.2.3.1.1.1.2.1.1.2.5]
b. 24 Jan 1804 d. 23 Aug 1805
11
Chloe Ann Benson
[1.2.3.1.1.1.2.1.1.2.6]
b. 23 Aug 1806
+
Dan Hill
b. 29 Nov 1796
11
Susan Augusta Benson
[1.2.3.1.1.1.2.1.1.2.7]
b. 9 Oct 1809 d. 25 Jul 1831
Preserved Smith Thayer
b. 9 May 1808
12
Susan Benson Thayer
[1.2.3.1.1.1.2.1.1.2.7.1]
b. 28 Jun 1831 d. 14 Aug 1909
11
Rufus Aldrich Benson
[1.2.3.1.1.1.2.1.1.2.8]
b. 9 Oct 1809
+
Sarah E Buell
11
Stephen Sibley Benson
[1.2.3.1.1.1.2.1.1.2.9]
b. 9 Jan 1810 d. 20 Nov 1869
Elizabeth Richardson Scott
b. 8 Jan 1835 d. 20 Feb 1911
12
Jessie Harriet Benson
[1.2.3.1.1.1.2.1.1.2.9.1]
b. 7 Jun 1860
12
Fred Mellen Benson
[1.2.3.1.1.1.2.1.1.2.9.2]
b. 10 Nov 1862 d. 9 May 1864
12
Susie Adeline Benson
[1.2.3.1.1.1.2.1.1.2.9.3]
b. 6 Aug 1865
9
Ebenezer Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.1.2]
b. 9 Oct 1745
Mary Chase
b. 15 Mar 1741 d. 1784
10
Sarah Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.1.2.1]
b. 19 Dec 1772
10
Lucy Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.1.2.2]
b. 2 Mar 1775
+
Forbes Bond
b. Abt 1773
10
Eunice Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.1.2.3]
b. 1 Mar 1777
10
Elias Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.1.2.4]
b. 8 Aug 1779 d. 1856
Ruth Chase
b. 31 Jan 1780 d. Abt 1858
11
Alonzo Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.1.2.4.1]
b. 14 Jul 1810 d. 16 Mar 1896
Mary Heath
b. 10 Sep 1813 d. 1836
12
Son Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.1.2.4.1.1]
b. 20 Oct 1836 d. 5 Dec 1836
Sarah Ann Heath
b. 10 Apr 1812 d. 1873
12
Daughter Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.1.2.4.1.2]
b. 1838 d. 7 Jul 1838
12
Mary Jane Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.1.2.4.1.3]
b. 17 Nov 1840 d. 15 Feb 1922 [
=>
]
12
Harriet A Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.1.2.4.1.4]
b. 25 Nov 1842 d. 6 Jul 1886 [
=>
]
12
Watson A Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.1.2.4.1.5]
b. 1844 d. 24 Apr 1924 [
=>
]
12
Judson L Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.1.2.4.1.6]
b. Oct 1846 [
=>
]
+
Adeline Colby
b. 10 Jun 1818 d. 18 Mar 1896
10
Ebenezer Sibley, Jr
[1.2.3.1.1.1.2.1.2.5]
b. 18 Jan 1782 d. 15 Mar 1827
Polly B Whipple
b. 16 Jun 1791
11
Lorinda Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.1.2.5.1]
b. 6 Jul 1810
+
Charles Arnold
11
Maria Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.1.2.5.2]
b. 23 Jul 1812
Whitcomb Gray
b. Abt 1804 d. 10 Jan 1888
12
Delia Maria Gray
[1.2.3.1.1.1.2.1.2.5.2.1]
b. 1834
12
Mary Ann Grey
[1.2.3.1.1.1.2.1.2.5.2.2]
c. 20 Mar 1836
11
Polly Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.1.2.5.3]
b. 11 Sep 1814
11
Mary Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.1.2.5.4]
b. 8 Mar 1817 d. 17 Jun 1903
Benjamin Cragin
b. 6 Mar 1814 d. 20 Jan 1896
12
Mary Emma Cragin
[1.2.3.1.1.1.2.1.2.5.4.1]
b. 12 Dec 1839 d. 25 Aug 1924 [
=>
]
12
Maria A Cragin
[1.2.3.1.1.1.2.1.2.5.4.2]
b. 27 Dec 1844
11
Loren Elba Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.1.2.5.5]
b. 3 May 1821
10
Zadock Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.1.2.6]
b. 12 Oct 1785
10
Mary Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.1.2.7]
b. 1 Feb 1789 d. 24 Apr 1844
+
Amos Peirce
b. Abt 1786 d. 22 Dec 1848
9
Abigail Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.1.3]
b. 22 Jan 1747
9
Peter Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.1.4]
b. 16 Sep 1749
9
Mary Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.1.5]
b. 20 Jan 1751
8
Stephen Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.2]
b. 1 Oct 1720
Mrs Sibley
b. Abt 1725
9
Elias Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.2.1]
b. Abt 1745
8
Bethiah Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.3]
b. 2 Oct 1724 d. 1 Jul 1756
Samuel Trask
b. 17 Dec 1721 d. 7 Mar 1790
9
John Trask
[1.2.3.1.1.1.2.3.1]
b. 29 Sep 1744
9
Hannah Trask
[1.2.3.1.1.1.2.3.2]
b. 10 Nov 1746
9
Sarah Trask
[1.2.3.1.1.1.2.3.3]
b. 10 Sep 1753 d. 22 Aug 1830
Major Simon Tenney
b. 13 Sep 1746 d. 14 Aug 1838
10
Major Daniel Tenney
[1.2.3.1.1.1.2.3.3.1]
b. 23 Nov 1773
Betsey Waters
b. 12 Jul 1776 d. 16 Aug 1851
11
Sarah Tenney
[1.2.3.1.1.1.2.3.3.1.1]
b. 6 Oct 1797 d. 13 Apr 1880
Edmond John Mills
b. 17 Aug 1791 d. 11 Sep 1889
12
Wiliam Edmund Mills
[1.2.3.1.1.1.2.3.3.1.1.1]
b. 2 Nov 1825 d. 18 Dec 1914 [
=>
]
12
Nancy Tenney Mills
[1.2.3.1.1.1.2.3.3.1.1.2]
b. 15 Mar 1828 d. 12 Jun 1880 [
=>
]
12
Samuel John Mills
[1.2.3.1.1.1.2.3.3.1.1.3]
b. 17 Nov 1830 d. 23 Jan 1838
12
Son Mills
[1.2.3.1.1.1.2.3.3.1.1.4]
b. 1 Mar 1835 d. 31 Mar 1835
12
Franklin Lewis Mills
[1.2.3.1.1.1.2.3.3.1.1.5]
b. 24 Oct 1836 d. 14 Feb 1918 [
=>
]
12
Sarah Maria Mills
[1.2.3.1.1.1.2.3.3.1.1.6]
b. 18 Aug 1841
11
Sally Tenney
[1.2.3.1.1.1.2.3.3.1.2]
b. 6 Oct 1797
11
Simon Tenney
[1.2.3.1.1.1.2.3.3.1.3]
b. 3 Dec 1799 d. 11 Jun 1856
Nancy Putnam
b. 17 Feb 1800
12
David Tenney
[1.2.3.1.1.1.2.3.3.1.3.1]
b. Abt 1830
12
Daniel Tenney
[1.2.3.1.1.1.2.3.3.1.3.2]
b. 29 Feb 1832 d. 6 Dec 1844
12
George Tenney
[1.2.3.1.1.1.2.3.3.1.3.3]
b. 30 Jan 1837 d. 29 Oct 1839
11
John Waters Tenney
[1.2.3.1.1.1.2.3.3.1.4]
b. 25 Jul 1802 d. 29 Apr 1849
Eliza Tileston Fisher
b. 13 May 1803 d. 21 Aug 1847
12
Edward Waters Tenney
[1.2.3.1.1.1.2.3.3.1.4.1]
b. Aug 1830 [
=>
]
11
Linus Tenney
[1.2.3.1.1.1.2.3.3.1.5]
b. 5 Dec 1804
Sally Elwell
b. 2 Dec 1806
12
Charles Linus Tenney
[1.2.3.1.1.1.2.3.3.1.5.1]
b. 12 Jan 1829 [
=>
]
12
George Franklin Tenney
[1.2.3.1.1.1.2.3.3.1.5.2]
b. 7 Sep 1831 d. 24 Nov 1831
12
James Henry Tenney
[1.2.3.1.1.1.2.3.3.1.5.3]
b. 10 Jun 1838 [
=>
]
11
Nancy Tenney
[1.2.3.1.1.1.2.3.3.1.6]
b. 21 Jan 1808 d. 29 May 1822
11
Danial Austin Tenney
[1.2.3.1.1.1.2.3.3.1.7]
b. 29 Aug 1811 d. 7 Feb 1871
Marietta Margaret Marcy
b. 11 Jun 1811
12
Daniel Austin Tenney
[1.2.3.1.1.1.2.3.3.1.7.1]
b. 15 Oct 1835 [
=>
]
12
Joseph Starks Tenney
[1.2.3.1.1.1.2.3.3.1.7.2]
b. 24 Feb 1838 [
=>
]
12
George Laban Tenney
[1.2.3.1.1.1.2.3.3.1.7.3]
b. 25 Jul 1840
12
Frederick Prescott Tenney
[1.2.3.1.1.1.2.3.3.1.7.4]
b. 6 Jul 1845
12
Frank Herbert Tenney
[1.2.3.1.1.1.2.3.3.1.7.5]
b. 16 Jan 1849 [
=>
]
11
Benjamin Franklin Tenney
[1.2.3.1.1.1.2.3.3.1.8]
b. 28 Oct 1813 d. 26 Oct 1900
Frances Bridges Veagie
b. 7 Mar 1819 d. 24 Oct 1858
12
Joseph Franklin Tenney
[1.2.3.1.1.1.2.3.3.1.8.1]
b. 12 Nov 1838 d. 1878
Mary Bowman Viles
b. 17 Feb 1831
12
Frank Tenney
[1.2.3.1.1.1.2.3.3.1.8.2]
b. 4 Feb 1861
12
Arthur Tenney
[1.2.3.1.1.1.2.3.3.1.8.3]
b. 1 Jun 1863 d. 16 Jun 1866
12
Maud Tenney
[1.2.3.1.1.1.2.3.3.1.8.4]
b. 13 May 1875 d. 30 Jun 1896 [
=>
]
9
Samuel Trask, Jr
[1.2.3.1.1.1.2.3.4]
b. 26 Aug 1749
Ruth Tenney
b. 16 Mar 1753 d. 27 Apr 1789
10
Samuel Trask, III
[1.2.3.1.1.1.2.3.4.1]
b. 10 Dec 1773
10
Simon Trask
[1.2.3.1.1.1.2.3.4.2]
b. 13 Jan 1775
10
Hannah Trask
[1.2.3.1.1.1.2.3.4.3]
b. 4 Feb 1777
10
Stephen Trask
[1.2.3.1.1.1.2.3.4.4]
b. 18 Feb 1779
10
Salley Trask
[1.2.3.1.1.1.2.3.4.5]
b. 17 Jan 1784 d. 5 Feb 1819
Elijah Holman
11
Jonathan Holman
[1.2.3.1.1.1.2.3.4.5.1]
b. 21 Jun 1813 d. 24 Oct 1816
11
Sarah Trask Holman
[1.2.3.1.1.1.2.3.4.5.2]
b. 16 May 1816 d. 8 May 1847
Sherman Hale
b. Abt 1812
12
Anna Hale
[1.2.3.1.1.1.2.3.4.5.2.1]
b. Abt 1838
12
Ann Hale
[1.2.3.1.1.1.2.3.4.5.2.2]
b. 1840
12
Emily Hale
[1.2.3.1.1.1.2.3.4.5.2.3]
b. Jul 1841 d. 2 Nov 1906
12
Anna H Hale
[1.2.3.1.1.1.2.3.4.5.2.4]
b. Feb 1843 d. 5 Jan 1929
12
Sarah Frank Hale
[1.2.3.1.1.1.2.3.4.5.2.5]
b. 16 Dec 1844 d. 30 Oct 1933
12
Charles T H Hale
[1.2.3.1.1.1.2.3.4.5.2.6]
b. 1846
11
Son Holman
[1.2.3.1.1.1.2.3.4.5.3]
b. Abt 1819 d. 23 Feb 1826
Allice Perry
b. Abt 1759
10
Talmon Trask
[1.2.3.1.1.1.2.3.4.6]
c. 6 Oct 1799
10
Danforth Trask
[1.2.3.1.1.1.2.3.4.7]
c. 27 Nov 1801
10
Dexter Trask
[1.2.3.1.1.1.2.3.4.8]
c. 11 Aug 1807
10
Edwin Trask
[1.2.3.1.1.1.2.3.4.9]
c. 29 Sep 1809
10
Angelina Trask
[1.2.3.1.1.1.2.3.4.10]
c. 26 Oct 1811
9
Anne Trask
[1.2.3.1.1.1.2.3.5]
b. 9 Oct 1757
8
Timothy Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4]
b. 2 Nov 1727 d. 6 Dec 1818
Ann Waite
b. 14 Oct 1733 d. 12 Mar 1791
9
John Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.1]
b. 19 May 1757 d. 8 Apr 1837
Betsey Hopkins
b. Abt 1754 d. 1790
10
George Champlin Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.1.1]
b. 1 Apr 1782 d. 31 Jan 1863
+
Mary Smith Easton
b. 24 Jan 1800 d. 20 Jun 1878
9
Timothy Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2]
b. 19 Jun 1754 d. 26 Aug 1829
Mary
b. Abt 1756
10
Timothy Willard Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.1]
b. 11 Sep 1779 d. 11 Mar 1820
Elizabeth Comins
d. 2 Mar 1820
11
William C Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.1.1]
b. 20 Jun 1812
11
Sarah Elizabeth Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.1.2]
b. 2 Jan 1814
11
Mary Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.1.3]
b. 26 Sep 1815
11
Amanda M Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.1.4]
b. 25 Jun 1817
11
Nancy W Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.1.5]
b. 10 Jul 1819
Francis S Putney
b. 20 Oct 1818
12
William Frank Putney
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.1.5.1]
b. 23 Sep 1844 d. 11 Feb 1847
12
Frank Edward Putney
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.1.5.2]
b. 12 Apr 1847 d. Dec 1849
12
William Sibley Putney
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.1.5.3]
b. 24 Mar 1849 d. 16 Jan 1933
12
Clara A Putney
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.1.5.4]
b. 28 Sep 1850
12
Mary Ann Putney
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.1.5.5]
b. 25 Dec 1852 d. 13 May 1881 [
=>
]
12
Josephine E Putney
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.1.5.6]
b. 16 Dec 1854 d. 26 Dec 1857
12
Orrin F Putney
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.1.5.7]
b. 20 Dec 1856 d. 20 Mar 1881
12
Luther C Putney
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.1.5.8]
b. 26 Jul 1859 d. 1920 [
=>
]
12
Fred Willard Putney
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.1.5.9]
b. 21 Jan 1866 d. 26 Dec 1930 [
=>
]
11
Almira S Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.1.6]
10
Mary Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.2]
b. 5 Dec 1780
+
Amariah Scarboro
10
Anne Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.3]
b. 15 Jan 1782
10
Cyrus Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.4]
b. 6 Jan 1784
Eliza Ann Humphries
b. 9 Sep 1809 d. 4 Oct 1884
11
Artemas Origin Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.4.1]
b. 9 Mar 1829
Eloise Soria
12
Robert A Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.4.1.1]
b. 25 Nov 1855 d. 18 Jul 1902
12
Artemise Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.4.1.2]
b. 1861
12
Eugene Walter Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.4.1.3]
b. 25 Mar 1865 d. 23 Apr 1945 [
=>
]
12
Cyrus Artemas Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.4.1.4]
b. 25 Aug 1866 d. 25 Aug 1949 [
=>
]
12
Hattie S Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.4.1.5]
b. 1870
12
Annie Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.4.1.6]
b. 1872
12
William Soria Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.4.1.7]
b. 12 Sep 1874 d. 12 Feb 1968
11
Salome Jane Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.4.2]
b. 19 Dec 1829 d. 12 Apr 1835
11
Artemesia Ann Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.4.3]
b. 31 Jul 1830 d. 1 Sep 1903
Robert Brown Searing
b. 15 May 1829 d. 2 May 1890
12
Robert Brian Searing
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.4.3.1]
b. 1859 d. 1878
12
Harry Pond Searing
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.4.3.2]
b. 1863 d. 20 Dec 1873
12
Cyrus Sibley Searing
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.4.3.3]
12
Florence Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.4.3.4]
12
Theodore Searing
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.4.3.5]
11
Willard Franklin Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.4.4]
b. 18 Apr 1835
11
Cyrus Blue Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.4.5]
b. 18 Apr 1837
11
Helena Jane Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.4.6]
b. 27 May 1839
11
Henrietta Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.4.7]
b. 1842 d. 6 Feb 1892
11
Walter Howard Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.4.8]
11
Augustus Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.4.9]
10
Artemas Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.5]
b. 21 Apr 1786
10
Salome Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.6]
b. 13 Apr 1788 d. Aft 1880
Elijah Jewett
b. 8 Feb 1782 d. 1879
11
John F Jewett
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.6.1]
b. 1817
+
Elizabeth How
b. Abt 1819
11
Origin Sibley Jewett
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.6.2]
b. 20 Apr 1820 d. 19 Sep 1863
Clara Lee James
b. 25 Oct 1832 d. 1912
12
Origin Sibley Jewett
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.6.2.1]
b. 1860 d. 1908 [
=>
]
11
Mary Elizabeth Jewett
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.6.3]
b. Abt 1821 d. 1901
Armistead M Elgin
b. 1819
12
Isabella Elgin
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.6.3.1]
b. 20 May 1857 d. 30 May 1924 [
=>
]
12
Willie A Elgin
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.6.3.2]
b. 18 Jan 1860 d. 12 Apr 1875
12
Clara J Elgin
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.6.3.3]
b. Abt 1863 d. 25 Apr 1959
12
Elizabeth May Elgin
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.6.3.4]
b. 1867 d. 24 Jan 1936
10
Benijamin Franklin Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.7]
b. 19 Jul 1790
10
Origen Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.8]
b. 1792 d. 1870
Elizabeth Barlow
b. 8 May 1815 d. 2 Jul 1875
11
Josephine Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.1]
b. 2 Jul 1835 d. 3 Mar 1873
George W Barnaby
d. 1859
12
Bessie Barnaby
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.1.1]
b. 14 Jan 1857
12
George Adam Barnaby
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.1.2]
b. 14 Jan 1857 d. 1897
William Motley Stevens
d. 1870
12
Lloyd Motley Stevens
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.1.3]
b. 13 Jan 1869 d. 13 Jun 1955
11
Salome Elizabeth Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.2]
b. 19 Aug 1837 d. 1 Nov 1893
Nathaniel Ragan King
b. 18 Jun 1831 d. 19 Nov 1863
12
Marietta King
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.2.1]
b. 8 Sep 1858 [
=>
]
12
Sibley Paul King
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.2.2]
b. 5 Jun 1860
12
Idyl King
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.2.3]
b. 23 Feb 1862 [
=>
]
12
Nathalie Ragan King
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.2.4]
b. 6 May 1863 [
=>
]
11
Origen Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.3]
b. 6 Feb 1840
Harriet A Brainerd
b. 1 Feb 1845
12
James Brainard Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.3.1]
b. 15 May 1869
12
Origen Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.3.2]
b. 30 Jun 1872
12
Orlean Emma Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.3.3]
b. 30 Jun 1872 d. 27 Oct 1872
12
Will Owen Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.3.4]
b. 1 May 1880 d. 13 Aug 1880
11
Laura Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.4]
b. 1842
William G McNeill
12
Mary Elizabeth McNeill
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.4.1]
b. 8 Mar 1865 [
=>
]
12
William Stoddard McNeill
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.4.2]
b. 6 Dec 1866 d. 14 Apr 1868
12
Laurence Harvey McNeill
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.4.3]
b. 10 Aug 1869
12
Fanny Ethel McNeill
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.4.4]
b. 21 May 1871
12
Daniel McNeill
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.4.5]
b. 22 Sep 1872
12
Lila Douglas McNeill
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.4.6]
b. 10 Apr 1877 d. 1954
11
Franklin Edward Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.5]
b. 1844
Ida K Sterne
12
Helen May Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.5.1]
b. 1879 d. 1880
12
Frank Eillott Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.5.2]
b. 1881 d. 1943
12
Ida Valerie Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.5.3]
b. 1883 d. 1979
12
Julian Dannis Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.5.4]
b. 1885 d. 1964
12
Rowland Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.5.5]
b. 1890 d. 1901
11
Helen Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.6]
b. 15 Dec 1846 d. 1940
Audubon Gullette
12
Laura Helen Gullette
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.6.1]
b. 30 Oct 1867 [
=>
]
12
Elizabeth Gullette
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.6.2]
b. 1869
12
Eugenia Gullette
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.6.3]
b. 9 Mar 1874
11
Charles Sweet Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.7]
b. 25 Jan 1849
Edna G D'Olive
b. 1872
12
Edna Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.7.1]
b. Dec 1890 d. 1987
11
Eugene Wilson Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.8]
b. 16 Sep 1851 d. 4 Mar 1911
Minnie M Sterne
12
Edward Austin Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.8.1]
d. 1960
12
Elizabeth Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.8.2]
d. 1896
12
Laurence Sterne Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.8.3]
d. 1901
11
Guy Clarence Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.9]
b. 1855
Susie Witherspoon Shipman
b. 29 Apr 1858 d. 27 Mar 1934
12
Guy Clarence Shipley, Jr
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.9.1]
b. 28 Jan 1883 d. 21 Feb 1912
11
Julia Eve Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.10]
b. 16 Jan 1856
Edward L Barnes
b. 23 Jan 1850
12
Anderson Barnes
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.10.1]
b. 28 Oct 1877
12
Origen Sibley Barnes
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.10.2]
b. 2 Sep 1879 d. 1884
12
Edward L Barnes
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.10.3]
12
Pendleton Barnes
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.10.4]
12
Sager Barnes
[1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.10.5]
9
Joshua Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.3]
b. 16 Nov 1755 d. 29 Sep 1774
9
Stephen Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.4]
b. 19 May 1757 d. 2 Jun 1759
9
Stephen Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.5]
b. 10 Nov 1759 d. 21 Apr 1829
9
Ebenezer Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.6]
b. 7 Apr 1761 d. 10 Sep 1839
Lydia Beach
b. 15 May 1766 d. 6 Mar 1834
10
John Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.6.1]
b. 3 Jul 1791
Nancy Kellog
b. 12 Mar 1809 d. 13 Jun 1885
11
Huldah Ann Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.6.1.1]
b. 13 Dec 1839 d. 30 Aug 1874
Carlos C Martin
b. 28 Dec 1819 d. 23 Oct 1894
12
Carlos Sibley Martin
[1.2.3.1.1.1.2.4.6.1.1.1]
b. 22 Jul 1866 d. 19 Jun 1952 [
=>
]
12
George Chapman Martin
[1.2.3.1.1.1.2.4.6.1.1.2]
b. 17 May 1868 d. 23 Jun 1921
11
Ebenezer Kellogg Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.6.1.2]
b. 21 Sep 1841 d. 29 Sep 1895
+
Ellen Welty
b. 21 Jul 1848 d. 8 Sep 1931
11
George Whitney Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.6.1.3]
b. 17 Jan 1843 d. 7 Jul 1911
Mary L Woodward
b. 21 Sep 1845 d. 1 Jan 1876
12
George Woodward Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.6.1.3.1]
b. 2 Apr 1869 d. 3 Nov 1941 [
=>
]
12
John Whitney Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.6.1.3.2]
b. 19 Jan 1875
Reteena Jasmine Sanders
b. 26 Apr 1850 d. 2 Jun 1929
12
Anna May Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.6.1.3.3]
b. 28 Oct 1879 d. 4 Sep 1962 [
=>
]
12
Elizabeth Kellogg Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.6.1.3.4]
b. 29 Aug 1884 d. 6 Sep 1943
12
John Whitney Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.6.1.3.5]
b. 17 Mar 1886 d. 29 Jul 1976
11
John Nelson Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.6.1.4]
b. 10 Nov 1844 d. 4 Jan 1880
11
Benjamin Franklin Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.6.1.5]
b. 5 Aug 1846 d. 1907
Lucia Marion Hill
b. 27 Dec 1848
12
Delia M Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.6.1.5.1]
b. 1874 d. 1876
12
William H Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.6.1.5.2]
b. 1877 d. 1888
12
Arthur K Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.6.1.5.3]
b. 1882 d. 1888
12
Hiram W Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.6.1.5.4]
b. 1884 d. 1886
12
George H Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.6.1.5.5]
b. 1892 d. 1893
11
Hiram Beach Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.6.1.6]
b. 4 Mar 1849 d. 20 Sep 1876
+
Mary Ann Wheeler
b. 13 Apr 1851 d. 25 Jan 1926
10
Timothy Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.6.2]
b. 4 Feb 1803 d. 24 Sep 1880
9
Anna Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.7]
b. 15 Dec 1762 d. 17 Sep 1792
Samuel Hoyt
b. 24 Jan 1739 d. 22 Nov 1821
10
Lydia Hoyt
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.1]
b. 9 Apr 1779 d. Aft 1850
Jonathan Bean
b. 26 Feb 1776 d. 9 Nov 1844
11
Sopia Bean
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.1.1]
b. 16 Jun 1799
11
Fanny Bean
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.1.2]
b. 20 Jan 1801
11
Otis Bean
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.1.3]
b. 26 Dec 1802
11
Asa Bean
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.1.4]
b. 13 Mar 1805 d. 18 Apr 1856
Jane D Stone
b. 20 Jan 1820 d. 30 Jul 1896
12
Leenze Bean
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.1.4.1]
b. 4 Sep 1840 d. 1 Mar 1841
12
Julia Ann Judson Bean
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.1.4.2]
b. 15 Feb 1842 d. 7 Jul 1927
12
Adeniran Judson Bean
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.1.4.3]
b. Abt 1843 d. 12 Jun 1888
12
Harriet Newell Bean
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.1.4.4]
b. 21 Jun 1847 d. 25 Dec 1928
12
William Gustin Bean
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.1.4.5]
b. 8 Jan 1850 d. 5 Apr 1850
12
Fanny Jeanette Bean
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.1.4.6]
b. 28 May 1852 [
=>
]
12
Margaret Jane Bean
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.1.4.7]
b. 6 Mar 1855
11
Synthia Bean
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.1.5]
b. 26 Dec 1807 d. 15 Oct 1816
11
Eliza Bean
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.1.6]
b. 26 Dec 1807 d. 15 Oct 1816
11
Rueben C Bean
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.1.7]
b. 2 Apr 1809
+
Elizabeth
11
Ann Bean
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.1.8]
b. 22 May 1811
11
Mary Bean
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.1.9]
b. 2 May 1813
11
Martha Bean
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.1.10]
b. 15 Dec 1815 d. 6 Jan 1818
10
Anna Hoyt
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.2]
b. 26 Sep 1781 d. 16 Sep 1865
Paulus Tenney
b. 24 Sep 1781 d. 29 Sep 1841
11
Maria Tenney
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.2.1]
b. 4 Jun 1805 d. 1 May 1812
11
Franklin Tenney
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.2.2]
b. 5 Nov 1806 d. 15 Nov 1878
11
Nancy S Tenney
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.2.3]
b. 28 Oct 1808 d. 1885
James French
b. 1 Apr 1815
12
Rebecca Ann French
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.2.3.1]
b. 26 Jan 1838
12
James Paulus French
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.2.3.2]
b. 4 Apr 1840
12
Mary Elizabeth French
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.2.3.3]
b. 24 Aug 1842
12
Jonathan John French
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.2.3.4]
b. 31 Jan 1845
12
Samuel S French
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.2.3.5]
b. 21 Dec 1847 d. 12 Jan 1851
12
William Harris French
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.2.3.6]
b. 29 Oct 1850 d. 11 Jan 1851
12
Solon Tenney French
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.2.3.7]
b. 15 Oct 1851 d. 27 Dec 1908
11
Sylvainus Tenny
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.2.4]
b. 6 Oct 1810 d. 12 Oct 1888
Mary Jane Bay
b. 21 Mar 1818
12
Paul Hugh Tenney
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.2.4.1]
b. 1 May 1839 d. 29 Sep 1868 [
=>
]
12
Arkalon Tenney
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.2.4.2]
b. 26 Jun 1841 [
=>
]
12
Curtis Monroe Tenney
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.2.4.3]
b. 2 Aug 1847 d. 10 Dec 1850
12
William Lafayette Tenney
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.2.4.4]
b. 30 Apr 1851 [
=>
]
12
Zilpha Tenney
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.2.4.5]
b. 1853 d. 1856
12
Mary Mariah Tenney
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.2.4.6]
b. 4 Sep 1844 d. 15 Jan 1933 [
=>
]
12
James F Tenney
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.2.4.7]
b. 1856 [
=>
]
10
William Hoyt
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.3]
b. 24 Jul 1783 d. 19 Feb 1813
Polly French
b. Abt 1785
11
Freeman Hoyt
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.3.1]
b. 1805
11
Mary French Hoyt
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.3.2]
b. Abt 1809
+
Cheney
b. Abt 1845
11
Sewell Hoyt
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.3.3]
b. Abt 1811
11
William Hoyt
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.3.4]
b. Abt 1813
11
French Hoyt
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.3.5]
b. Abt 1815
10
Sarah Hoyt
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.4]
b. 13 Feb 1786 d. 14 Nov 1862
John Hoyt
b. 2 Dec 1787
11
Sophronia Hoyt
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.4.1]
b. 21 Dec 1810 d. 12 Feb 1889
Joel Blackman
b. 21 Dec 1810 d. 22 Jun 1901
12
True Worthy Blackman
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.4.1.1]
b. 27 Nov 1836 d. 16 Jan 1925 [
=>
]
12
John Monroe Blackman
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.4.1.2]
b. 1852 d. 7 Jun 1871
12
Virgil W Blackman
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.4.1.3]
b. 3 Jul 1857 d. 1921 [
=>
]
11
William Hoyt
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.4.2]
b. 12 Oct 1813
+
Mrs Hoyt
11
Samuel True Hoyt
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.4.3]
b. Abt 1814
11
True Worthy Hoyt
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.4.4]
b. 31 Aug 1815 d. 1900
Phebe Ann Jameson
b. 1820
12
Phoebe Sophronia Hoyt
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.4.4.1]
b. 12 May 1847 d. 4 Aug 1849
12
Sarah Elizabeth Hoyt
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.4.4.2]
b. 16 Aug 1850 d. 22 Jan 1855
12
True Worthy Hoit
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.4.4.3]
b. 15 May 1853
12
Elisabeth Jamison Hoit
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.4.4.4]
b. 16 Jun 1856
12
Homer A Hoit
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.4.4.5]
b. 17 Dec 1858 d. 28 Feb 1923
12
Fanny Story Hoyt
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.4.4.6]
b. 19 Oct 1861
11
Albert Lewis Hoyt
[1.2.3.1.1.1.2.4.7.4.5]
b. 23 Dec 1822 d. 10 Aug 1843
9
Asa Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.8]
b. 29 Mar 1764 d. 25 Feb 1829
Irene Carpenter
b. 28 Jan 1766 d. 5 Oct 1846
10
Derick Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.8.1]
b. 22 May 1788 d. Abt 1846
Rachael Roberts
b. 1800 d. Aft 1860
11
Caroline Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.8.1.1]
b. 1833 d. Aft 1860
W L Evans
b. 1827 d. Aft 1860
12
Anna B Evans
[1.2.3.1.1.1.2.4.8.1.1.1]
b. 1852 d. Aft 1860
10
Sophia Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.8.2]
b. 5 Oct 1790 d. 4 Feb 1841
Oren Hall
b. 1789 d. Dec 1820
11
Sophia Edna Hall
[1.2.3.1.1.1.2.4.8.2.1]
b. 1 Apr 1809 d. 1870
Edwin Thomson
b. 1808 d. Abt 1857
12
Mortimer Neal Thomson
[1.2.3.1.1.1.2.4.8.2.1.1]
b. 2 Sep 1831 d. 25 Jun 1875 [
=>
]
12
Clifford Thomson
[1.2.3.1.1.1.2.4.8.2.1.2]
b. 15 Apr 1834 d. 29 Sep 1912 [
=>
]
11
Edwin Oscar Hall
[1.2.3.1.1.1.2.4.8.2.2]
b. 21 Oct 1810 d. 19 Sep 1883
Sarah Lyon Williams
b. 27 Oct 1812 d. 15 Aug 1876
12
Sophia Elizabeth Hall
[1.2.3.1.1.1.2.4.8.2.2.1]
b. 4 Jul 1836 d. 26 May 1863 [
=>
]
12
Caroline Alice Hall
[1.2.3.1.1.1.2.4.8.2.2.2]
b. 5 Nov 1839 d. 29 Jan 1868
12
William Wisner Hall
[1.2.3.1.1.1.2.4.8.2.2.3]
b. 1 Jun 1841 d. 23 May 1910 [
=>
]
12
Cornelia Hall
[1.2.3.1.1.1.2.4.8.2.2.4]
b. 25 Aug 1842 d. 27 Apr 1911 [
=>
]
+
Mary Lyon Dame
b. 6 Oct 1848 d. 16 Mar 1908
11
Asa Sibley Hall
[1.2.3.1.1.1.2.4.8.2.3]
b. 23 Apr 1818
Joseph Willard Seymour
b. 29 Mar 1781 d. 25 Jan 1867
11
Oren T Seymour
[1.2.3.1.1.1.2.4.8.2.4]
b. 1824
11
Mary E. Seymour
[1.2.3.1.1.1.2.4.8.2.5]
b. Abt 1825 d. Aft 1850
11
Theodore S. Seymour
[1.2.3.1.1.1.2.4.8.2.6]
b. 1 Jul 1828 d. 1902
10
Lucy Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.8.3]
b. 21 Jul 1792 d. 18 Jul 1795
10
Levi Waite Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.8.4]
b. 4 Mar 1801 d. 13 Aug 1844
Nancy Ann Remington
b. 18 Sep 1801 d. 9 Jan 1870
11
Augustus Furburt Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.8.4.1]
b. 15 Jul 1827
Mary Williamsen Ogden
b. 20 May 1838 d. 15 Jan 1890
12
Herman Clark Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.8.4.1.1]
b. 22 Nov 1860
11
Amanda Maria Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.8.4.2]
b. 25 Oct 1829 d. 31 Mar 1861
John Francis Hoyt
b. 18 Oct 1816
12
Harriet M Hoyt
[1.2.3.1.1.1.2.4.8.4.2.1]
b. 19 Oct 1849
11
William Wisner Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.8.4.3]
b. 4 Feb 1831 d. 30 Jun 1870
+
Helen Jane Wilcox
b. 31 Aug 1831
11
Harriet Remington Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.8.4.4]
b. 12 Jul 1833 d. Aug 1844
11
George Ainsworth Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.8.4.5]
b. 13 Jun 1834 d. 29 Dec 1856
11
Levi Edwin Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.8.4.6]
b. 8 Sep 1839 d. 29 Oct 1900
Sarah Ella Martling
b. Oct 1852 d. 28 Dec 1932
12
Lucy M Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.8.4.6.1]
b. 1876 d. 1888
12
William W Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.8.4.6.2]
b. Dec 1877 [
=>
]
12
George Edwin Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.8.4.6.3]
b. 24 Jun 1881
10
Mary Ann Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.8.5]
b. 18 Dec 1804 d. 18 Oct 1870
Edwin Scrantom
b. 9 May 1803 d. 3 Oct 1880
11
Stella Benton Scrantom
[1.2.3.1.1.1.2.4.8.5.1]
b. 12 Jan 1827
+
Galusha Phillips
b. 27 Apr 1820 d. 1880
11
Adrian George Scrantom
[1.2.3.1.1.1.2.4.8.5.2]
b. 26 Oct 1828 d. 1880
+
Mary Sheldon
b. Abt 1832
+
Charlotta
d. 1880
+
Helen Jane Wilcox
b. 31 Aug 1831 d. Abt 1900
11
Cora Irene Scrantom
[1.2.3.1.1.1.2.4.8.5.3]
b. 28 Jun 1830 d. 31 Dec 1858
John E Sabine
b. Abt 1826 d. 7 Jul 1854
12
Cora Lovisa Sabine
[1.2.3.1.1.1.2.4.8.5.3.1]
b. 30 Jan 1850
12
Mary Irene Sabine
[1.2.3.1.1.1.2.4.8.5.3.2]
b. 8 Jan 1853 [
=>
]
12
Sibly Phillips Sabine
[1.2.3.1.1.1.2.4.8.5.3.3]
b. 23 Dec 1854
George Williams
b. 24 Nov 1831 d. 10 Feb 1895
12
Child Williams
[1.2.3.1.1.1.2.4.8.5.3.4]
b. 31 Dec 1858 d. 31 Dec 1858
11
Edwina Jane Scrantom
[1.2.3.1.1.1.2.4.8.5.4]
b. 24 Sep 1832 d. Abt 1839
11
Hamlet Edwin Scrantom
[1.2.3.1.1.1.2.4.8.5.5]
b. Abt 1833 d. Abt 1833
11
Beulah Mary Scrantom
[1.2.3.1.1.1.2.4.8.5.6]
b. 15 Jan 1835 d. 1 Jan 1900
Isaac H Weaver
b. Abt 1831 d. Bef 1867
12
Edwin James Weaver
[1.2.3.1.1.1.2.4.8.5.6.1]
b. 1857 d. 12 Aug 1874
Ensley Mills Smith
b. 8 Aug 1828 d. 7 May 1886
12
Emmalita A Smith
[1.2.3.1.1.1.2.4.8.5.6.2]
b. 12 Apr 1868 d. 29 Sep 1879
12
Mary Elizabeth Smith
[1.2.3.1.1.1.2.4.8.5.6.3]
b. 6 Jul 1870 d. 13 Oct 1879
12
Ensley Boyd Smith
[1.2.3.1.1.1.2.4.8.5.6.4]
b. 10 Jan 1876 d. 7 Aug 1956
11
Edwin Levi Scrantom
[1.2.3.1.1.1.2.4.8.5.7]
b. Abt 1837 d. Abt 1837
11
Clifford Sibley Scrantom
[1.2.3.1.1.1.2.4.8.5.8]
b. Abt 1841 d. Abt 1844
11
Melford Clark Scrantom
[1.2.3.1.1.1.2.4.8.5.9]
b. 4 Nov 1844 d. Abt 1845
11
Bertha Sibley Scranton
[1.2.3.1.1.1.2.4.8.5.10]
b. 29 Nov 1848
10
George Ainsworth Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.8.6]
b. 9 Apr 1809 d. 1 Jun 1836
10
Daughter Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.8.7]
c. 1 Oct 1809 d. 1809
9
Jonathan Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.9]
b. 8 May 1766 d. 20 Feb 1823
Mary Davis
b. 24 Feb 1768 d. 23 Jun 1840
10
Davis Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.9.1]
b. 29 Nov 1788 d. 21 Nov 1828
Cynta Fisher
b. Abt 1797 d. 6 Jul 1874
11
Nelson Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.9.1.1]
b. 4 Mar 1820 d. 10 Mar 1850
11
Franklin Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.9.1.2]
b. 1 Oct 1821 d. 1878
Julia Badger Leavitt
b. 29 Jul 1826 d. 28 Jan 1864
12
Mary Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.9.1.2.1]
b. 1847
12
Frederick M Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.9.1.2.2]
b. Jun 1849 d. 2 Oct 1912
12
Davis Origin Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.9.1.2.3]
b. 28 Jun 1853 d. 22 May 1913
12
George F Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.9.1.2.4]
b. Sep 1853
12
Walter Frank Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.9.1.2.5]
b. Sep 1857 d. 4 Jun 1911 [
=>
]
12
John L Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.9.1.2.6]
b. 1859
Ellen W Floyd
b. 1836 d. 1 Jul 1878
12
Ernia M Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.9.1.2.7]
b. Jun 1878 d. 12 Jul 1878
12
Ena L Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.9.1.2.8]
b. Jun 1878 d. 30 Jun 1878
11
Laura Messenger Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.9.1.3]
b. 6 Dec 1822 d. 13 Jan 1861
11
Mary Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.9.1.4]
b. 15 Apr 1825 d. 21 Aug 1826
11
Martha Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.9.1.5]
b. 18 Jun 1826 d. Sep 1826
11
Mary Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.9.1.6]
b. 7 Aug 1827 d. 16 Oct 1840
11
Caroline F Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.9.1.7]
b. 14 Dec 1828 d. 7 Apr 1853
+
Cyrus Harris
10
Mary Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.9.2]
b. 13 Apr 1792 d. 9 Nov 1844
Augustine White
b. 19 Jan 1777
11
Mary Ann White
[1.2.3.1.1.1.2.4.9.2.1]
b. 19 Apr 1812 d. 12 May 1823
11
Eliza Malvina White
[1.2.3.1.1.1.2.4.9.2.2]
b. 30 Nov 1814 d. 7 Apr 1858
+
Henry W Nichols
11
Cynthia Sibley White
[1.2.3.1.1.1.2.4.9.2.3]
b. 8 May 1818
11
Augusta Holven White
[1.2.3.1.1.1.2.4.9.2.4]
b. 28 Jan 1821
+
Daniel Scott
11
Lucy Violy White
[1.2.3.1.1.1.2.4.9.2.5]
b. 20 Oct 1824 d. Jul 1845
11
John S White
[1.2.3.1.1.1.2.4.9.2.6]
b. 2 Jul 1827
+
Emilie Jouret
11
Davis J White
[1.2.3.1.1.1.2.4.9.2.7]
b. 27 Jan 1833
10
Jonathan W Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.9.3]
b. 13 Aug 1800 d. 26 Sep 1829
Brooksey Case
b. 30 Sep 1804 d. 15 Mar 1829
11
Albert C Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.9.3.1]
b. 3 Jun 1828 d. Feb 1852
9
Benjamin Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.10]
b. 29 Apr 1768 d. 2 Oct 1829
Zilpah Davis
b. 13 Apr 1771 d. 16 May 1824
10
Samuel Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.10.1]
b. 30 Nov 1792 d. 4 Mar 1858
Lucinda Holbrock
b. 19 Mar 1806 d. 2 Mar 1830
11
Giles H Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.10.1.1]
b. 26 May 1825 d. 10 Jun 1825
11
Morella Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.10.1.2]
b. 19 Jun 1827 d. 31 Jul 1849
11
Lucinda Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.10.1.3]
b. 12 Jul 1829 d. 4 Sep 1854
Almira Dixon
b. 3 Apr 1807
11
Elizabeth H Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.10.1.4]
b. 20 Nov 1833
+
Joseph Fisk
11
Mary Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.10.1.5]
b. 16 Jan 1838 d. 17 Aug 1839
11
Helen Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.10.1.6]
b. 23 Sep 1842 d. 3 Feb 1844
11
George H Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.10.1.7]
b. 25 Aug 1845
+
Theodocia Townsend
10
Patty Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.10.2]
b. 6 Feb 1799 d. 12 Jul 1805
10
Nancy Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.10.3]
b. 7 Feb 1806 d. 14 Feb 1806
10
Hiram Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.10.4]
b. 6 Feb 1807 d. 12 Jul 1888
Elizabeth Maria Tinker
b. 11 Aug 1815 d. 11 Jul 1903
11
Zilpha Louisa Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.10.4.1]
b. 7 Dec 1833 d. 16 Jun 1868
Hobart Ford Atkinson
b. 5 Oct 1825 d. 14 Aug 1908
12
Marie Louise Atkinson
[1.2.3.1.1.1.2.4.10.4.1.1]
b. 24 Feb 1864 d. 29 Oct 1940
12
Elizabeth Storer Atkinson
[1.2.3.1.1.1.2.4.10.4.1.2]
b. Abt 1866 bur. 16 Feb 1945
11
Giles Benjamin Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.10.4.2]
b. 8 Apr 1841 d. 14 Mar 1843
11
Hiram Watson Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.10.4.3]
b. 2 Mar 1845 d. 28 Jun 1932
Margaret Durbin Harper
b. 14 Feb 1852 d. 28 May 1939
12
Margaret Harper Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.10.4.3.1]
b. 14 Dec 1873 d. 30 Nov 1874
12
Hiram Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.10.4.3.2]
b. 24 Jul 1875 d. 12 Apr 1886
12
John Durbin Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.10.4.3.3]
b. 3 Nov 1883 d. 18 Sep 1888
12
Fletcher Harper Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.10.4.3.4]
b. 5 Apr 1885 d. 24 Apr 1959 [
=>
]
12
Margaret Urling Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.10.4.3.5]
b. 17 Jan 1893 d. 3 Apr 1951
11
Emily Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.10.4.4]
b. 10 May 1855 d. 8 Feb 1945
Isaac Seymour Averill
b. 21 Jun 1850 d. 25 Oct 1909
12
Elizabeth Louise Averell
[1.2.3.1.1.1.2.4.10.4.4.1]
b. 25 Jan 1877 d. 2 Apr 1886
12
James G Averell
[1.2.3.1.1.1.2.4.10.4.4.2]
b. 23 Dec 1877 d. 30 Nov 1904
James Sibley Watson
b. 11 Mar 1860 d. 1951
12
James Sibley "Sibley" Watson, Jr
[1.2.3.1.1.1.2.4.10.4.4.3]
b. 10 Aug 1894 d. 31 Mar 1982 [
=>
]
9
Soloman Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.11]
b. 17 Nov 1769
Sally Stockwell
b. 21 Jan 1774
10
Stephen Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.11.1]
b. 12 Dec 1792
10
Nancy Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.11.2]
b. 19 Jan 1797
+
Nathan Muzzy
b. 24 Dec 1792 d. 23 Jun 1858
10
Heister Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.11.3]
b. 19 Jun 1799
10
Lewis Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.11.4]
b. 8 Jul 1801
10
Stephen Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.11.5]
b. 26 Jul 1805
Charlotte Reed Peirce
b. 7 Jul 1811 d. 22 Aug 1882
11
John Reed Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.11.5.1]
b. 18 Apr 1838
11
George H Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.11.5.2]
b. 17 Aug 1841
+
Emma J Gould
b. 8 Jul 1850
11
Martha P Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.11.5.3]
b. 16 Nov 1843
11
Mary Charlotte Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.11.5.4]
b. 18 May 1847
Albert Marritt Phillips
b. 9 Oct 1843
12
Clara Willis Phillips
[1.2.3.1.1.1.2.4.11.5.4.1]
b. 13 May 1884
11
Clara Sophronia Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.11.5.5]
b. 8 Nov 1849
Otis Sumner Pond
b. 3 Nov 1846
12
Arthur N Pond
[1.2.3.1.1.1.2.4.11.5.5.1]
b. 1 Mar 1873
12
Herbert Carroll Pond
[1.2.3.1.1.1.2.4.11.5.5.2]
b. 26 May 1877 d. 7 Dec 1930 [
=>
]
10
Solomon Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.11.6]
b. 14 Jun 1808
10
John Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.11.7]
b. 20 Feb 1818 d. 17 Aug 1824
9
Polly Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.12]
b. 4 Dec 1771
Abner C Cummings
b. 9 Oct 1770 d. 1800
10
Nancy Cummings
[1.2.3.1.1.1.2.4.12.1]
b. 5 Nov 1795
John Putnam
b. Abt 1792
11
Dulcina Putnam
[1.2.3.1.1.1.2.4.12.1.1]
b. 12 Dec 1813 d. 20 Jul 1816
11
Harriet Putnam
[1.2.3.1.1.1.2.4.12.1.2]
b. 20 Mar 1815 d. 20 Jul 1816
11
Jane Putnam
[1.2.3.1.1.1.2.4.12.1.3]
b. 1 Nov 1816
Walters Putnam
b. 16 Mar 1817
12
Sarah Jane Putnam
[1.2.3.1.1.1.2.4.12.1.3.1]
b. 1 Nov 1841
12
Nancy L Putnam
[1.2.3.1.1.1.2.4.12.1.3.2]
b. 15 Aug 1845
12
Marble Putnam
[1.2.3.1.1.1.2.4.12.1.3.3]
b. 19 Aug 1847 [
=>
]
12
Martha Waters Putnam
[1.2.3.1.1.1.2.4.12.1.3.4]
b. 3 Nov 1849 d. 8 Feb 1856
12
Henry Waters Putnam
[1.2.3.1.1.1.2.4.12.1.3.5]
b. 1 Oct 1855
11
John Perry Putnam
[1.2.3.1.1.1.2.4.12.1.4]
b. 27 Mar 1818
11
Ira Putnam
[1.2.3.1.1.1.2.4.12.1.5]
b. 15 Nov 1819 d. 12 May 1821
11
Ephraim Laughton Putnam
[1.2.3.1.1.1.2.4.12.1.6]
b. 30 Apr 1821 d. 3 Dec 1822
10
Clarissa Cummings
[1.2.3.1.1.1.2.4.12.2]
b. 18 Apr 1796 d. 1838
Creenfield Pote Merrill
b. 26 Aug 1794 d. 27 Mar 1876
11
Edward Pote Merrill
[1.2.3.1.1.1.2.4.12.2.1]
b. 22 Oct 1820 d. 1870
+
Olive B Lincoln
b. 1823
11
Elizabeth C Merrill
[1.2.3.1.1.1.2.4.12.2.2]
b. 26 Feb 1822 d. 16 Dec 1839
11
Greenfield Merrill
[1.2.3.1.1.1.2.4.12.2.3]
b. 14 Dec 1825
11
Samuel Merrill
[1.2.3.1.1.1.2.4.12.2.4]
b. 28 Oct 1832 d. 1912
11
Creenfield Merrill
[1.2.3.1.1.1.2.4.12.2.5]
b. 14 Dec 1834
11
Daniel Cummings Merrill
[1.2.3.1.1.1.2.4.12.2.6]
b. 20 Mar 1837 d. 1925
+
Mary A Noyes
b. 23 May 1841 d. 28 Feb 1893
9
Artamus Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.13]
b. 9 Jul 1773 d. 10 Aug 1777
9
Nahum Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.14]
b. 11 Sep 1775 d. 12 Sep 1796
9
Sally Sibley
[1.2.3.1.1.1.2.4.15]
b. 6 Jun 1779 d. 21 Mar 1833
Amasa Cummings
b. 17 Jan 1778 d. 22 Mar 1836
10
Abner Cummings
[1.2.3.1.1.1.2.4.15.1]
b. 1 Jan 1808
10
Sarah Ann Cummings
[1.2.3.1.1.1.2.4.15.2]
b. 22 Oct 1812
10
Nahum Sibley Cummings
[1.2.3.1.1.1.2.4.15.3]
b. 7 Jan 1816
+
Hannah Amidon
b. Abt 1730 d. 5 Jun 1822
7
Jonathan Sibley
[1.2.3.1.1.1.3]
b. 1 May 1690 d. Abt 1733
Mary Cutler
b. 19 Mar 1691 d. 1734
8
Martha Sibley
[1.2.3.1.1.1.3.1]
b. 10 Jul 1731
7
Hannah Sibley
[1.2.3.1.1.1.4]
c. 9 May 1695 d. 8 Feb 1731
Ebenezer Daggett
b. 22 Nov 1693 d. 8 Apr 1762
8
Ebenezer Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.1]
b. 13 Apr 1723 d. Bef 3 Aug 1761
8
Thomas Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2]
b. 21 Apr 1725 d. 28 Nov 1758
Martha Stockwell
b. 25 Mar 1724
9
Captain John Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.1]
b. 15 Sep 1748 d. 8 Feb 1816
Mary Stevens
b. 1749
10
Thomas Dagget
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.1]
b. 5 Aug 1776
Ruth Record
c. 25 Jan 1777
11
Elisha Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.1.1]
b. Abt 1801 d. Abt 1881
11
Ruth Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.1.2]
b. Abt 1804 d. 1881
11
Thomas Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.1.3]
b. Abt 1806
10
John Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.2]
b. 14 Oct 1778 d. 6 Jan 1824
Sarah Record
b. 1780 d. 25 Oct 1821
11
Luther Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.2.1]
b. 19 Nov 1800
11
Betsey Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.2.2]
b. 25 Nov 1802
John Harris
b. 31 Dec 1799
12
Palina Harris
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.2.2.1]
b. Abt 1831
12
Sarah Harris
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.2.2.2]
b. Abt 1833
12
Benton Harris
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.2.2.3]
b. Abt 1834
12
Amelia Harris
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.2.2.4]
b. Abt 1836
12
Almira Harris
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.2.2.5]
b. Abt 1839
11
Calvin Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.2.3]
b. 24 Jan 1806 d. 1 Jul 1832
Laura Mower
b. 24 May 1805 d. 21 Mar 1863
12
Luther S Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.2.3.1]
b. 3 Jan 1826 d. 29 Nov 1873 [
=>
]
12
Calvin K Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.2.3.2]
b. 22 Feb 1828
12
Henry T Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.2.3.3]
b. 13 Feb 1830
12
Luella Jane Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.2.3.4]
b. 15 Jul 1832
12
Laura Ann Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.2.3.5]
b. 15 Jul 1832 d. 17 Sep 1887
11
Sarah Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.2.4]
b. 27 Dec 1809 d. 30 Jun 1832
11
Lucy Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.2.5]
b. 15 Aug 1812
11
Anna Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.2.6]
b. 26 Nov 1814
11
John Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.2.7]
b. 16 Nov 1817
11
Silas Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.2.8]
b. 20 Jun 1821
10
Sarah Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.3]
b. 2 Apr 1780 d. 1873
Captain Samuel Bates
b. Abt 1776
11
Florentine Bates
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.3.1]
b. Abt 1802
11
Simeon Bates
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.3.2]
b. Abt 1804
11
Marilla Bates
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.3.3]
b. Abt 1806
11
Sarah Bates
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.3.4]
b. Abt 1808
10
Simeon Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.4]
b. Abt 1782
10
Simon Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.5]
b. 1786 d. 1807
10
Captain Aaron Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.6]
b. 4 Mar 1787 d. 1 Feb 1862
Almira Dearborn
b. 7 May 1789 d. 11 Mar 1830
11
Greenlief Dearborn Quincy Adams Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.6.1]
b. 10 Nov 1818 d. 23 Jul 1854
11
Converse Rollin Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.6.2]
b. 14 Mar 1820
Anna F Packard Bailey
b. 11 Jun 1845
12
Emma Rose Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.6.2.1]
b. 4 Dec 1880
11
Simon Dearborn Alfred Pierce Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.6.3]
b. 19 Sep 1822 d. 11 Aug 1840
11
Molly Dearborn Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.6.4]
b. 13 Apr 1826 d. 23 Apr 1826
11
Almira Augusta Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.6.5]
b. 28 Sep 1827 d. 27 Mar 1865
+
Isaac Cotton Merrill
b. Abt 1823
Dorcas C Dearborn
b. 13 Jun 1796 d. 24 Mar 1869
11
Ebenezer Sanborn Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.6.6]
b. 30 Sep 1831
11
John Carroll Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.6.7]
b. 29 Jul 1833 d. 12 Dec 1902
Abigail Chandler Fogg
b. 18 Jul 1851 d. 4 Sep 1877
12
Aaron Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.6.7.1]
b. 19 Dec 1871
12
Augusta Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.6.7.2]
b. 3 Aug 1873
12
Walter Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.6.7.3]
b. Jan 1875
11
Mary Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.6.8]
b. 9 Jan 1835 d. 1 Oct 1861
11
Brigadier General Aaron Simon Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.6.9]
b. 14 Jan 1837 d. 14 May 1931
Martha Rosetta Bradford
b. 11 Sep 1840
12
Mary Augusta Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.6.9.1]
b. 21 Oct 1868
12
Royal Bradford Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.6.9.2]
b. 13 Nov 1870
12
Alice Southworth Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.6.9.3]
b. 11 Aug 1872
12
Helen Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.6.9.4]
b. 1 Sep 1881
10
Mary Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.7]
b. 5 Jul 1789
Luther Robbins
b. Abt 1785
11
Louisiana Robbins
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.7.1]
b. Abt 1811
11
Survetus Robbins
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.7.2]
b. Abt 1813
11
Mary Robbins
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.7.3]
b. Abt 1815
11
John Robbins
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.7.4]
b. Abt 1817
11
Clementine Robbins
[1.2.3.1.1.1.4.2.1.7.5]
b. Abt 1819
+
Sarah Jones
b. 26 Oct 1749 d. Bef 1775
9
Mary Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.2]
b. 29 Mar 1750 d. Aft 25 Sep 1826
Seth Corbett Jones
b. 21 Mar 1748 d. 14 Apr 1827
10
Samuel Jones
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.1]
b. 5 Aug 1773 d. 24 Aug 1846
Matilda Davis
b. 13 Aug 1777 d. Aft 1820
11
Reuben Davis Jones
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.1.1]
b. 30 Jul 1798 d. 22 Feb 1866
Harriet Dennis Ryan
b. 10 Mar 1799 d. 30 Dec 1891
12
Albert Davis Jones
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.1.1.1]
b. 29 Jul 1824 d. 5 Sep 1889 [
=>
]
12
Sarah Jones
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.1.1.2]
b. 26 Jun 1826 d. 24 Sep 1827
12
Julia Madeline Jones
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.1.1.3]
b. 7 Jun 1828 d. 9 Jan 1916 [
=>
]
12
Henry Orlando Jones
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.1.1.4]
b. 25 Feb 1831 d. Bef 1870 [
=>
]
12
Caroline Matilda Jones
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.1.1.5]
b. 25 Jul 1834 d. 15 Sep 1848
12
Jonathan Edward Jones
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.1.1.6]
b. 16 Jun 1840 d. 15 Aug 1855
11
Seth Corbitt Jones
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.1.2]
b. 23 Sep 1800 d. 21 Jul 1867
Isabel Richardson
b. 29 Jun 1801 d. 29 Mar 1885
12
Seth John Jones
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.1.2.1]
b. 6 Sep 1824 d. 24 Feb 1831
12
William Richardson Jones
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.1.2.2]
b. 12 Aug 1825 d. 19 Apr 1895 [
=>
]
12
Morris Jones
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.1.2.3]
b. 12 Mar 1828 d. 2 Feb 1829
12
Henry George Jones
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.1.2.4]
b. 29 Jun 1830 d. 21 Jan 1888 [
=>
]
12
Hobart Jones
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.1.2.5]
b. 4 Jun 1832 d. 14 Mar 1887 [
=>
]
12
Heber C Jones
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.1.2.6]
b. 24 Dec 1835 d. 17 Apr 1896 [
=>
]
12
Mary Elizabeth Jones
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.1.2.7]
b. 11 Sep 1838 d. 24 Jul 1854
11
Sallie Jones
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.1.3]
b. 1802
11
Ezra Jones
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.1.4]
b. 1804 d. 1807
11
Ezra Jones
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.1.5]
b. 12 Jul 1807 d. 3 Aug 1879
Hannah Maria Jones
b. 1812 d. 2 May 1841
12
John Emory Jones
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.1.5.1]
b. Feb 1841 d. 30 Dec 1904 [
=>
]
Ann Myatt
b. Abt 1806 d. 12 Mar 1870
12
Mary W Jones
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.1.5.2]
b. 1844 d. 27 Jun 1917
+
Catherine Doyle
b. 1843 d. 14 Feb 1886
Lucinda Kingsley
b. 21 Jan 1798 d. 23 Dec 1882
11
Frederick Jones
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.1.6]
b. 22 Feb 1819 d. 8 Jul 1849
11
William Henry Jones
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.1.7]
b. 22 Oct 1820 d. 21 Aug 1909
11
Samuel Jones
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.1.8]
b. 13 Oct 1822 d. 1839
11
Nathaniel Vary Jones
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.1.9]
b. 13 Oct 1822 d. 15 Feb 1863
Caroline Martin Garr
b. 7 Jul 1836 d. 2 Nov 1912
12
Mark Vary Jones
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.1.9.1]
b. 3 Jan 1863 d. 1 Mar 1930 [
=>
]
11
Calvin Kingsley Jones
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.1.10]
b. 9 Jul 1824 d. 30 Oct 1915
Polly Baxter
b. 11 Oct 1797 d. 6 Jan 1851
11
Isabel Jones
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.1.11]
b. 16 Jan 1836 d. 6 Mar 1913
Hobart Jones
b. 4 Jun 1832 d. 14 Mar 1887
12
Caroline Jones
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.1.11.1]
b. 1857 d. 1870
12
William Jones
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.1.11.2]
b. 1859 d. Bef 1870
12
Alfred Hobart Jones
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.1.11.3]
b. 14 Nov 1862 d. 28 Aug 1922 [
=>
]
12
Mary E Jones
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.1.11.4]
b. 1867 d. Abt 1897 [
=>
]
11
Harriet Jones
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.1.12]
b. 2 Apr 1838 d. Aft 1855
10
Aaron Jones
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.2]
b. 23 Mar 1775
10
Sarah Jones
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.3]
b. 23 Sep 1777 d. 17 May 1838
Joel Pratt
b. Abt 1776 d. 18 May 1866
11
Reuben Pratt
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.3.1]
b. 13 Nov 1803 d. 31 May 1861
Mary T
12
Joel F Pratt
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.3.1.1]
b. 27 Sep 1830 d. 1919 [
=>
]
12
Mary Esther Pratt
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.3.1.2]
b. 22 Aug 1834
12
Sarah J Pratt
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.3.1.3]
b. 1837
12
Jacob Elbridge Pratt
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.3.1.4]
b. 12 Dec 1838
12
Nelson Reuben Pratt
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.3.1.5]
b. Abt 1841 d. 31 Mar 1895 [
=>
]
12
Marilla Sarah Pratt
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.3.1.6]
b. 1844
Olive Fitzgerald
b. 13 Jun 1816
12
Henrietta F. Pratt
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.3.1.7]
b. 1850 d. 19 Feb 1934
11
Nelson Chapin Pratt
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.3.2]
b. 18 Jul 1805 d. 14 Mar 1864
Artemesia Hammond
b. 5 May 1809
12
Sarah Jones Pratt
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.3.2.1]
b. 13 May 1828 d. 14 Dec 1862 [
=>
]
12
Martha Baker Pratt
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.3.2.2]
b. 7 Nov 1830
12
Maria Hammond Pratt
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.3.2.3]
b. Abt 1834 d. 28 Dec 1863
12
Artimisha Pratt
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.3.2.4]
b. Abt 1835
Julia Abbie Gowen
b. Abt 1818 d. 9 Oct 1886
12
George Oscar Pratt
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.3.2.5]
b. 4 Apr 1845 d. 1 May 1929 [
=>
]
12
Francis A Pratt
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.3.2.6]
b. Apr 1847 d. 1945 [
=>
]
12
William A Pratt
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.3.2.7]
b. Abt 1850
12
Nelson Chapman Pratt
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.3.2.8]
b. 31 Oct 1851 d. 1912 [
=>
]
12
Lillie Pratt
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.3.2.9]
b. Abt 1854
11
Seth Corbett Pratt
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.3.3]
b. 2 Sep 1807 d. 2 Jun 1880
Mary Herring
b. 2 Feb 1813 d. 22 Nov 1895
12
Cyntha B Pratt
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.3.3.1]
b. 21 Mar 1835 d. 28 May 1928 [
=>
]
12
Henry Otis Pratt
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.3.3.2]
b. 11 Feb 1838 d. 22 May 1901 [
=>
]
12
George William Pratt
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.3.3.3]
b. 13 Aug 1840 d. 18 Apr 1910 [
=>
]
12
Emilie H Pratt
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.3.3.4]
b. 16 Dec 1849
11
Lawson Pratt
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.3.4]
b. 13 Sep 1810
Caroline
b. 1814
12
Eugene Abba Pratt
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.3.4.1]
b. 14 Jul 1837
11
Esther Pratt
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.3.5]
b. 12 Dec 1812
Daniel Mansfield
b. 20 Dec 1808
12
Joseph D Mansfield
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.3.5.1]
b. 1842
12
Stacy Tucker Mansfield
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.3.5.2]
b. 19 May 1845 [
=>
]
12
Julia L Mansfield
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.3.5.3]
b. 1846 d. 20 Apr 1894
12
Seth C P Mansfield
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.3.5.4]
b. 1848
12
Sarah A Mansfield
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.3.5.5]
b. 1850
12
Wooster P Mansfield
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.3.5.6]
b. 1852 [
=>
]
12
Charles O Mansfield
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.3.5.7]
b. 1855
11
Marilla May Pratt
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.3.6]
b. 3 Sep 1814 d. 4 Mar 1835
11
Joel Pratt
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.3.7]
b. 3 Sep 1817 d. 1822
11
Sarah Jane Pratt
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.3.8]
b. 30 Aug 1819 d. 12 May 1838
10
Mary Jones
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.4]
b. 9 Dec 1780 d. 30 Oct 1831
John Bigelow
b. 12 Aug 1787 d. 6 Sep 1808
11
Mary Dagget Bigelow
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.4.1]
b. 4 Apr 1807 d. 6 Mar 1873
Varnum Brigham
b. 8 Jul 1802 d. 25 Jul 1848
12
Persis Penelope Brigham
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.4.1.1]
b. 1 Aug 1825 d. 4 Jan 1851
12
Mary Jones Brigham
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.4.1.2]
b. 14 Jun 1827 d. 25 Sep 1827
12
Calvin L Brigham
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.4.1.3]
b. 8 Sep 1828 d. 15 Oct 1850
12
Sarah J Brigham
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.4.1.4]
b. 23 Sep 1830 d. 23 Jan 1856
12
Varnum Bigelow Brigham
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.4.1.5]
b. 21 Feb 1833 d. Abt 1893 [
=>
]
12
Emery P Brigham
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.4.1.6]
b. 18 Jan 1835 d. Jan 1835
12
Mary Lucy Brigham
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.4.1.7]
b. 18 May 1836 d. 1872 [
=>
]
12
Frances Felicia Brigham
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.4.1.8]
b. 3 Sep 1838 d. 24 May 1900 [
=>
]
12
Martha A Brigham
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.4.1.9]
b. 25 Jul 1840 d. 1864
12
John A Brigham
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.4.1.10]
b. 18 Sep 1843 d. 2 Aug 1854
12
Abby H Brigham
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.4.1.11]
b. 31 Dec 1845 d. Abt 1905 [
=>
]
11
John Jones Bigelow
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.4.2]
b. 31 Jan 1809 d. 2 Jun 1848
Susan McKinstry
b. 1 Jun 1816 d. 8 Nov 1891
12
John Karresty Bigelow
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.4.2.1]
b. 7 Aug 1836 d. 21 Aug 1836
12
Andrew Laroy Bigelow
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.4.2.2]
b. 16 Aug 1840 [
=>
]
10
Lydia Jones
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.5]
b. 15 Oct 1783
10
Seth Corbett Jones, Jr
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.6]
b. 16 Oct 1785 d. 27 May 1807
10
Altheda Jones
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.7]
b. 27 Oct 1787 d. 28 Mar 1790
10
Cynthia Jones
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.8]
b. 13 May 1791 d. 5 Jan 1827
10
Rachel Jones
[1.2.3.1.1.1.4.2.2.9]
b. 23 Apr 1793 d. 3 May 1823
9
David Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.3]
b. 27 Jun 1751 d. 14 May 1777
Bulah Johnson
b. 1750
10
Azubah Dagget
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.1]
b. 15 Mar 1774
Daniel Town
b. 1774
11
Betsy Town
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.1.1]
b. 1795 d. 13 Feb 1890
Abegence Weld
b. 12 Mar 1795 d. 5 Nov 1848
12
William Weld
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.1.1.1]
b. 1817 [
=>
]
12
Damon Weld
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.1.1.2]
b. 1820 d. 6 Jun 1847
12
Deborah Weld
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.1.1.3]
b. 1822
12
Russell Weld
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.1.1.4]
b. 18 Jun 1824 d. 5 May 1904
12
Philena Weld
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.1.1.5]
b. 1828 d. 9 Jun 1898 [
=>
]
12
Adaline Elizabeth Weld
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.1.1.6]
b. Abt 1833 d. 2 Jan 1914 [
=>
]
12
Daniel Weld
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.1.1.7]
b. 1834 d. 9 Dec 1899 [
=>
]
Azubah Wheelock
b. 15 Jan 1745 d. 8 Feb 1804
10
Lyman Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.2]
b. 22 Aug 1775 d. 30 Apr 1870
Sarah West Hathaway
b. 22 Feb 1785
11
Catherine H Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.2.1]
b. 27 Aug 1807 d. 19 Jan 1890
Loam Hathaway
b. 15 Sep 1803 d. 26 Sep 1883
12
Edwin Augustus Hathaway
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.2.1.1]
b. 1 Feb 1831 d. 29 Mar 1835
12
Martin Van Buren Hathaway
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.2.1.2]
b. 21 Sep 1837 d. 3 Jan 1894
12
Fernando Cortez Hathaway
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.2.1.3]
b. 29 Aug 1844 d. 6 Jul 1873 [
=>
]
12
Lyman Daggett Hathaway
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.2.1.4]
b. 29 Aug 1833 d. 27 May 1890 [
=>
]
11
Clarissa Amanda Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.2.2]
b. 22 Oct 1810 d. 7 Jan 1879
Chester Bugbee
b. 21 Sep 1808 d. 22 May 1875
12
Walter S Bugbee
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.2.2.1]
b. 20 Mar 1818 d. 1 Apr 1825
12
Sarah West Bugbee
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.2.2.2]
b. 4 Jan 1835
12
Willard Chester Bugbee
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.2.2.3]
b. 19 Jul 1836 d. 11 Jun 1918 [
=>
]
12
Julia Amanda Bugbee
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.2.2.4]
b. 19 Aug 1838 d. 9 Aug 1863
12
Catherine Reliance Bugbee
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.2.2.5]
b. 11 Feb 1841 [
=>
]
12
Maria E Bugbee
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.2.2.6]
b. 6 Apr 1843 [
=>
]
12
William Wallace Bugbee
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.2.2.7]
b. 5 Apr 1845 d. 22 Aug 1846
12
Walter S Bugbee
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.2.2.8]
b. 3 Mar 1848 d. 7 Jul 1863
12
Emma Arvilla Bugbee
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.2.2.9]
b. 19 Jan 1849 d. 25 May 1881 [
=>
]
11
Pardon Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.2.3]
b. 14 Feb 1818 d. 1 Apr 1825
10
David Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.3]
b. 31 Jan 1776 d. 28 Sep 1861
Hannah Moffett
b. 7 Jan 1776 d. 31 Jan 1810
11
Sally Learned Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.1]
b. 13 Apr 1799 d. Bef 1834
+
Thomas Pray
b. 1801 d. 12 Jan 1876
11
Azubah Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.2]
b. 8 Mar 1802 d. 3 May 1881
Jonathan Danforth
b. 11 May 1798 d. 23 Feb 1859
12
Philora A Danforth
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.2.1]
b. 1828 d. 15 Mar 1857
12
Augusta Danforth
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.2.2]
b. 1831 d. Aft 1850
12
Cynthia Danforth
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.2.3]
b. 1833 d. Aft 1850
12
Emily J Danforth
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.2.4]
b. 1834 d. 21 Aug 1853
12
Chancy B Danforth
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.2.5]
b. 1835 d. 19 May 1860
12
Helen M Danforth
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.2.6]
b. 1837 d. 17 Jan 1861
12
Sarah Jane Danforth
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.2.7]
b. 1839 d. Aft 1850
12
Harriet N Danforth
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.2.8]
b. 1842 d. 5 May 1862
11
Erasmus Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.3]
b. 13 Mar 1804
11
Asahel Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.4]
b. 15 Feb 1807 d. 13 Mar 1890
Eliza White
b. 15 Sep 1810 d. Mar 1861
12
Delia Ann Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.4.1]
b. May 1830 d. May 1861
12
William Penn Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.4.2]
b. 1834 [
=>
]
12
Caroline Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.4.3]
b. 1849 [
=>
]
11
Rheuphemia Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.5]
b. 19 Oct 1809
Elizabeth Tobey
b. 22 Nov 1791 d. 1862
11
Eli Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.6]
b. 7 Feb 1815 d. Abt 1815
11
Polly W Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.7]
b. 25 Feb 1818
11
Maria Keziah Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.8]
b. 20 Apr 1820 d. 2 Dec 1883
Thomas B Muldoon
b. 1820 d. 21 Apr 1870
12
James D Muldoon
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.8.1]
b. Jun 1847 d. 28 Dec 1906 [
=>
]
12
Frank M Muldoon
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.8.2]
b. Dec 1849
12
Clara Muldoon
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.8.3]
b. Abt 1855 d. 1883
12
Frederick B Muldoon
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.8.4]
b. 1858 d. 20 Feb 1888
12
Emma M Muldoon
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.8.5]
b. 1863 d. 1940
11
Lyman Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.9]
b. 22 Feb 1822 d. 26 Mar 1902
Mary E Belding
b. 1829 d. Bef 1900
12
Arthur B Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.9.1]
b. 1856 d. Aft 1910 [
=>
]
12
Freeman L Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.9.2]
b. 1858 d. 14 Feb 1935 [
=>
]
12
Bertha E Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.9.3]
b. Jul 1864 d. Aft 1900
11
Avery Tobey Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.10]
b. 16 Dec 1824 d. Aft 1880
Mary S
b. Apr 1848 d. Aft 1905
12
William Lee Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.10.1]
b. Jul 1869 d. Aft 1905
11
David Janson Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.11]
b. 4 May 1827 d. 30 Dec 1894
Katherine Roddy
b. Abt 1844 d. 13 Jul 1900
12
Abner Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.11.1]
b. 1861 d. Aft 1885
12
Fred E Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.11.2]
b. 23 Aug 1864 d. 7 Nov 1907
12
Eldridge Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.11.3]
b. Mar 1865 d. 1927
12
Edward R Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.11.4]
b. 1868 d. 21 Mar 1927
12
Frank M Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.11.5]
b. 21 Jun 1872 d. 18 Jul 1922 [
=>
]
12
Katheryn Carrie Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.11.6]
b. 11 Sep 1878 d. 22 Jun 1958
11
Cordelia Flavilla Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.12]
b. 3 Feb 1831 d. Aft 1900
John R Cooley
b. 1832 d. Bef 1900
12
Ella Cooley
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.12.1]
b. 1869 d. Bef 1900
11
Elizabeth Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.13]
b. Dec 1833
9
Hannah Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.4]
b. 23 Dec 1753
9
Martha Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.5]
b. 2 Jun 1755
Edward Wheelock
b. 1754
10
Relief Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.1]
b. 2 Sep 1777
10
Silas Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.2]
b. 20 Apr 1781 d. 30 Oct 1851
Rena Baldwin
b. 26 Feb 1778 d. 28 Jun 1833
11
Lewis Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.1]
b. 5 Dec 1807 d. 24 Dec 1881
Eliza Palmer
b. Abt 1813
12
Clarinda Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.1.1]
b. Abt 1832
12
Albert H Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.1.2]
b. Abt 1833 d. Aft 1912
12
Orlando Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.1.3]
b. 30 Jul 1834 d. 7 Nov 1900 [
=>
]
12
Mary Ann Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.1.4]
b. 11 Aug 1835 d. Abt 1874 [
=>
]
12
Lewis M Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.1.5]
b. Abt 1837
12
Almina Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.1.6]
b. Abt 1838
12
Fred Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.1.7]
b. Abt 1840
12
Irena Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.1.8]
b. Abt 1842
12
Cyrus Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.1.9]
b. Abt 1843
12
Phebe Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.1.10]
b. Abt 1845
11
Olive Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.2]
b. 9 Apr 1806
11
Albert Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.3]
b. 3 Jan 1805 d. 8 Jun 1875
Lisena Clark
b. 4 Jan 1811 d. 25 Jan 1894
12
Laura Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.3.1]
b. Abt 1831
12
Mariette Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.3.2]
b. Abt 1835
12
William H Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.3.3]
b. Abt 1837
12
Oscar F Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.3.4]
b. Abt 1841 [
=>
]
11
Scinda Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.4]
b. 16 Sep 1809 d. 14 Oct 1845
+
Michael Hutchinson
11
Silas B Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.5]
b. 6 Jun 1811 d. 16 Nov 1897
Phebe Smith
b. 26 Nov 1809 d. 8 Jul 1890
12
Julia Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.5.1]
b. 7 Jan 1836 d. 19 Jan 1865
12
Jane Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.5.2]
b. 7 Jul 1838 d. 3 May 1882
12
Martha S Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.5.3]
b. 22 Sep 1840 d. 14 Nov 1899
12
Hilton Haven Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.5.4]
b. 2 Apr 1843 d. 7 Oct 1925 [
=>
]
11
John Homer Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.6]
b. 26 May 1813 d. 28 Mar 1887
Sarah L Houghton
b. 29 Apr 1816 d. 16 Nov 1890
12
Amelia Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.6.1]
b. 1843 d. 1925 [
=>
]
12
Theodore Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.6.2]
b. 5 May 1844 d. 31 Dec 1898 [
=>
]
12
Agustus J Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.6.3]
b. 29 Dec 1848
12
Augusta Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.6.4]
b. 29 Dec 1848 d. 1900
12
Zenas Elmer Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.6.5]
b. 14 Apr 1849 d. 14 Feb 1926
12
Delia Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.6.6]
b. 18 Aug 1853 d. 4 Apr 1914
12
Delitah Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.6.7]
b. 18 Aug 1853 d. 1934
11
Harmon Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.7]
b. 13 Mar 1815 d. 1892
+
Amanda S Hill
b. Abt 1807 d. 27 Dec 1893
11
Nancy B Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.8]
b. 17 Sep 1817 d. 20 Dec 1842
11
Joseph S Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.9]
b. 1 Nov 1819 d. 21 Apr 1902
Paula Almira Crandall
b. 19 Sep 1826 d. 1899
12
Silas Stanton Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.9.1]
b. 30 Jun 1851 d. 25 Feb 1931 [
=>
]
12
Mary J Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.9.2]
b. 22 Nov 1852 d. 28 Sep 1870
12
Florence Ann Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.9.3]
b. 7 Jun 1854 d. May 1916 [
=>
]
12
Millard Fillmore Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.9.4]
b. 27 Aug 1856 d. 15 Feb 1931 [
=>
]
12
Lillian Victoria Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.9.5]
b. 29 Jul 1858 d. 1 Oct 1907 [
=>
]
11
Zenas S Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.10]
b. 29 Aug 1821 d. 25 May 1844
11
James Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.11]
b. 4 Jul 1824
11
Sophronia Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.12]
b. 25 Oct 1826
+
George Smith
+
Sarah Hurlbut
b. 21 Mar 1790 d. 1855
10
Lynda Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.3]
b. 15 Apr 1783
10
Reuben Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.4]
b. 23 Jul 1785 d. 29 Jul 1833
Rosanna Smiley
b. 5 Jun 1783 d. 30 Apr 1874
11
Agusta Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.4.1]
b. Abt 1806
11
Gillman Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.4.2]
b. Abt 1808
11
Sarah Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.4.3]
b. Abt 1810
11
Eliza Ann Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.4.4]
b. Abt 1812
11
Laurane Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.4.5]
b. 1 Sep 1814 d. 24 Mar 1884
Frederick S Benham
b. 2 Jan 1811 d. 21 Jul 1861
12
Mary Eliza Benham
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.4.5.1]
b. 1835 d. 31 Aug 1873 [
=>
]
12
Fernando Benham
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.4.5.2]
b. 15 Nov 1836 d. 7 Feb 1900 [
=>
]
12
Maria A Benham
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.4.5.3]
b. 1838 d. 1854
12
James Louis Benham
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.4.5.4]
b. 1841 d. 1861
12
Elizabeth Benham
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.4.5.5]
b. 1843
12
Frederick S Benham, Jr
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.4.5.6]
b. 1846
12
Francis M Benham
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.4.5.7]
b. 1849 d. 1915
12
Charles W Benham
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.4.5.8]
b. 1853 d. 1900
11
Emmons Howe Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.4.6]
b. 17 May 1817 d. 27 Apr 1899
Polly Wilson
b. Abt 1824 d. 6 Dec 1904
12
Mary Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.4.6.1]
b. 19 Jan 1848
12
George Washington Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.4.6.2]
b. 25 Dec 1849 d. 21 Jan 1935 [
=>
]
12
Warren J Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.4.6.3]
b. 16 Mar 1851 d. 23 Feb 1934 [
=>
]
12
Marion Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.4.6.4]
b. 12 Aug 1852 d. 19 Mar 1926
12
Eliza Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.4.6.5]
b. 26 Apr 1855 d. 21 Apr 1934
12
Martin Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.4.6.6]
b. 18 Jul 1856 d. 19 Oct 1923
12
Arthur Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.4.6.7]
b. 7 Mar 1858 d. 29 Dec 1937
12
Selden Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.4.6.8]
b. 24 Dec 1859 d. 9 Oct 1933 [
=>
]
12
Amos Solon Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.4.6.9]
b. Abt 1861 d. 1887
12
Olive L Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.4.6.10]
b. 25 Apr 1868 d. 10 Oct 1932
12
Ada Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.4.6.11]
b. Abt 1870
11
Caroline Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.4.7]
b. 29 Sep 1819
11
Andrew Jackson Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.4.8]
b. 1 Jun 1822 d. 31 May 1915
Mary Ann Gregory
b. 1 Jul 1826
12
Leah Josephine Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.4.8.1]
b. 14 Dec 1849
Bridget Mary Evans
b. 27 Dec 1826 d. 4 Apr 1904
12
William A Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.4.8.2]
b. 31 Jul 1856 d. 1862
12
Mary Elizabeth Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.4.8.3]
b. 21 Nov 1858 d. 15 Jul 1932 [
=>
]
12
George Harold Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.4.8.4]
b. 28 Oct 1860 [
=>
]
12
Rosanna William Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.4.8.5]
b. 23 Dec 1862 d. 1869
12
Charles J Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.4.8.6]
b. 1864 d. 1869
12
Charles J Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.4.8.7]
11
James Loren Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.4.9]
b. 28 Feb 1825 d. 6 Dec 1900
Irene Jane Haynes
b. 20 Nov 1827 d. 20 Feb 1905
12
Son Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.4.9.1]
b. 1848 d. 1848
12
Judson Wells Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.4.9.2]
b. 30 Dec 1851 d. 23 Oct 1936 [
=>
]
12
Antonette Jane Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.4.9.3]
b. 4 Jul 1856 d. 6 Apr 1863
12
Cora Marietta Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.4.9.4]
b. 26 Nov 1859 d. 19 Feb 1896
12
Rose Jane Wheelock
[1.2.3.1.1.1.4.2.5.4.9.5]
b. 8 Dec 1871 d. 1 Feb 1894
9
Aaron Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.6]
b. 12 Mar 1757 d. 3 Jun 1759
9
Lidia Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.2.7]
b. 4 Oct 1758 d. 23 Mar 1836
Naham Lamb
b. 13 Jul 1759 d. 22 May 1842
10
Amasa Lamb
[1.2.3.1.1.1.4.2.7.1]
b. 24 Jul 1786 d. 12 Jun 1815
10
Linda Lamb
[1.2.3.1.1.1.4.2.7.2]
b. 14 Oct 1788
+
Caleb Knight
b. 16 Sep 1780
10
Patee Lamb
[1.2.3.1.1.1.4.2.7.3]
b. 10 Jan 1791
10
Nahum Lamb
[1.2.3.1.1.1.4.2.7.4]
b. 4 Aug 1793
10
Lydia Lamb
[1.2.3.1.1.1.4.2.7.5]
b. 3 Feb 1796
10
Jason Lamb
[1.2.3.1.1.1.4.2.7.6]
b. 9 Oct 1798 d. 2 Aug 1873
Nancy Cruver
b. 5 Nov 1804 d. 14 Nov 1843
11
Salem Towne Lamb
[1.2.3.1.1.1.4.2.7.6.1]
b. 15 Oct 1823
11
George Washington Lamb
[1.2.3.1.1.1.4.2.7.6.2]
b. 1825
11
Erastus Wallace Lamb
[1.2.3.1.1.1.4.2.7.6.3]
b. 1826
11
Melinda Mary Lamb
[1.2.3.1.1.1.4.2.7.6.4]
b. 1829
11
Leonard Lamb
[1.2.3.1.1.1.4.2.7.6.5]
b. 1830 d. 1858
Melinda W Harmon
b. 17 Apr 1810 d. 31 Aug 1883
11
Ellen E Lamb
[1.2.3.1.1.1.4.2.7.6.6]
b. 1846 d. Bef 1923
Charles Henry Williams
b. 21 Jun 1845 d. 5 Jan 1911
12
Thomas Harmon Williams
[1.2.3.1.1.1.4.2.7.6.6.1]
b. 1867
12
Lora A Williams
[1.2.3.1.1.1.4.2.7.6.6.2]
b. 1871
12
Wallace J Williams
[1.2.3.1.1.1.4.2.7.6.6.3]
b. 1874
12
Kate Williams
[1.2.3.1.1.1.4.2.7.6.6.4]
b. 1877
11
Asenath H Lamb
[1.2.3.1.1.1.4.2.7.6.7]
b. Abt 1849 d. Bef 1923
11
Kate Lamb
[1.2.3.1.1.1.4.2.7.6.8]
b. 19 Dec 1853 d. 11 Jul 1936
Seba Samuel Bedient
b. 27 Aug 1855 d. 21 Jun 1917
12
Ona Elizabeth Bedient
[1.2.3.1.1.1.4.2.7.6.8.1]
b. 31 Jan 1881 d. 8 Sep 1936
12
Mary M Bedient
[1.2.3.1.1.1.4.2.7.6.8.2]
b. 10 Jun 1888
10
Gerson Lamb
[1.2.3.1.1.1.4.2.7.7]
b. 8 Aug 1800 d. 13 Nov 1885
Lois Fisk Bacon
b. 11 Nov 1801 d. 4 Sep 1884
11
Norval Bacon Lamb
[1.2.3.1.1.1.4.2.7.7.1]
b. 17 Apr 1827
11
Alvan Naham Lamb
[1.2.3.1.1.1.4.2.7.7.2]
b. 27 Jul 1828
11
Edwin Dagget Lamb
[1.2.3.1.1.1.4.2.7.7.3]
b. 18 Jul 1832
11
Henry Gersom Lamb
[1.2.3.1.1.1.4.2.7.7.4]
b. 27 Feb 1834
Ellen Augusta Bacon
b. 9 Nov 1838
12
Frank Henry Lamb
[1.2.3.1.1.1.4.2.7.7.4.1]
b. 14 Jun 1856
11
Theodore Fiske Lamb
[1.2.3.1.1.1.4.2.7.7.5]
b. 2 Sep 1836
11
Charles Francis Lamb
[1.2.3.1.1.1.4.2.7.7.6]
b. 15 Mar 1838
10
Washington Lamb
[1.2.3.1.1.1.4.2.7.8]
b. 6 May 1803
8
William Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3]
b. 15 Aug 1727 d. 15 Jan 1813
Thankful Gleason
b. 17 Jun 1738 d. 28 Dec 1813
9
Asa Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.1]
b. 7 Jul 1760 d. Abt 1830
Waitstill Monroe
b. 2 Jan 1764
10
Asel Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.1.1]
b. 16 Aug 1798 d. 6 Jan 1848
Elizabeth Barnes
b. 1804 d. 1 Jul 1891
11
Ann Elizabeth Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.1.1.1]
b. 13 Mar 1829 d. 21 Feb 1901
Luke Teeple
b. Abt 1828 d. 11 Feb 1923
12
Matilda E Teeple
[1.2.3.1.1.1.4.3.1.1.1.1]
b. 1 Oct 1848 d. 12 Oct 1951 [
=>
]
12
George Teeple
[1.2.3.1.1.1.4.3.1.1.1.2]
b. Abt 1852 d. 27 Jan 1941
12
Edgar Elisha Teeple
[1.2.3.1.1.1.4.3.1.1.1.3]
b. 1855 d. 25 Dec 1942 [
=>
]
12
Asa Henry Teeple
[1.2.3.1.1.1.4.3.1.1.1.4]
b. 23 Mar 1857 d. 18 May 1940 [
=>
]
12
Helen Elizabeth Teeple
[1.2.3.1.1.1.4.3.1.1.1.5]
b. 19 Apr 1857 d. 1904
12
Simon Peter Teeple
[1.2.3.1.1.1.4.3.1.1.1.6]
b. 1860 [
=>
]
12
Jessie Teeple
[1.2.3.1.1.1.4.3.1.1.1.7]
b. 6 Jul 1860 d. 8 Apr 1862
12
Minnie E Teeple
[1.2.3.1.1.1.4.3.1.1.1.8]
b. 15 Sep 1862 d. 7 Nov 1870
12
Florence A Teeple
[1.2.3.1.1.1.4.3.1.1.1.9]
b. 1864
12
Sherman Ulyssees Teeple
[1.2.3.1.1.1.4.3.1.1.1.10]
b. 27 Sep 1869
11
Jefferson Loren Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.1.1.2]
b. 1 Jan 1838 d. 16 Jun 1919
Mary Jane Ward
b. 6 Aug 1842 d. 14 Feb 1899
12
William Henry Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.1.1.2.1]
b. 16 Feb 1862 d. 27 May 1918 [
=>
]
12
Elisha Strong Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.1.1.2.2]
b. 7 Dec 1868 d. 16 Oct 1946 [
=>
]
12
Orlen Asa Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.1.1.2.3]
b. 15 Aug 1869 d. 22 Nov 1948 [
=>
]
12
Loran Elias Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.1.1.2.4]
b. 6 Jun 1872 d. 18 Mar 1935 [
=>
]
12
Andrew James Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.1.1.2.5]
b. 3 Feb 1874 d. 5 Feb 1936 [
=>
]
12
Truman Briant Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.1.1.2.6]
b. 6 Mar 1876 d. 31 Oct 1955 [
=>
]
12
Homer Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.1.1.2.7]
b. Abt 1877
12
Charles Grant Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.1.1.2.8]
b. 29 Sep 1880 d. 14 Oct 1943 [
=>
]
12
Delbert LeRoy Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.1.1.2.9]
b. 2 Sep 1882 d. 4 Jun 1951 [
=>
]
11
Julia Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.1.1.3]
b. 28 May 1837 d. 22 Apr 1921
Sidney A Crosby
b. 1831 d. 15 Sep 1901
12
Elery Adelbert Crosby
[1.2.3.1.1.1.4.3.1.1.3.1]
b. 11 Dec 1858 d. 20 Nov 1943 [
=>
]
12
Carrie Bell Crosby
[1.2.3.1.1.1.4.3.1.1.3.2]
b. 1861 d. 5 Nov 1932 [
=>
]
12
Laura Elizabeth Crosby
[1.2.3.1.1.1.4.3.1.1.3.3]
b. 2 Nov 1863 d. 18 Nov 1934 [
=>
]
12
Henry Foster Crosby
[1.2.3.1.1.1.4.3.1.1.3.4]
b. 18 May 1868 d. 21 Jan 1958 [
=>
]
12
George Marshal Crosby
[1.2.3.1.1.1.4.3.1.1.3.5]
b. 27 Oct 1870 d. 16 Dec 1922
12
Mary Crosby
[1.2.3.1.1.1.4.3.1.1.3.6]
b. 1879 d. 1879
11
Elisha S Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.1.1.4]
b. 1839
11
Electa Elizabeth Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.1.1.5]
b. Sep 1844
Delos D Stetson
b. 1837 d. 10 Jul 1884
12
Florence Stetson
[1.2.3.1.1.1.4.3.1.1.5.1]
b. Mar 1870
12
Alvin Stetson
[1.2.3.1.1.1.4.3.1.1.5.2]
b. 1872
12
Georgia Stetson
[1.2.3.1.1.1.4.3.1.1.5.3]
b. 9 Mar 1875 d. Sep 1949 [
=>
]
+
Henry J Porter
b. Jan 1840 d. 6 Apr 1918
11
Mary Louisa Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.1.1.6]
b. 1847
Marshall Lee Daggett
b. 12 Jan 1848
12
Robert Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.1.1.6.1]
b. 11 Nov 1869
12
Son Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.1.1.6.2]
b. 17 Nov 1869
12
Blanch Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.1.1.6.3]
b. 10 Aug 1874 d. 9 Mar 1880
12
Myron Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.1.1.6.4]
b. 14 Jul 1886 d. 13 May 1887
9
Anna Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.2]
b. 11 Sep 1762 d. Aft 1788
William Estey
b. 9 Aug 1759 d. 1843
10
Nabby Estey
[1.2.3.1.1.1.4.3.2.1]
b. 8 Jul 1791
10
Fanny Estey
[1.2.3.1.1.1.4.3.2.2]
b. 28 Mar 1793
10
Betsey Estey
[1.2.3.1.1.1.4.3.2.3]
b. 26 Apr 1795
10
Anna Estey
[1.2.3.1.1.1.4.3.2.4]
b. 25 Aug 1797
10
Gilman Estey
[1.2.3.1.1.1.4.3.2.5]
b. 14 Oct 1799 d. 14 Oct 1877
+
Louisa Thompson
b. 29 Apr 1819 d. 22 Feb 1885
10
Caroline Estey
[1.2.3.1.1.1.4.3.2.6]
b. 27 Dec 1801
+
George Rice
b. 1807
9
Phineas Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.3]
b. 22 Aug 1764
Betsey Wilson
b. 1769 d. 11 Aug 1791
10
William Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.3.1]
b. 21 Dec 1788 d. 2 Jun 1818
Clarissa Wait
b. 1791 d. 1862
11
William Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.3.1.1]
b. 1813 d. 16 May 1860
11
Clarissa Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.3.1.2]
b. 6 Mar 1815 d. 10 Nov 1890
Sidney Smith Campbell
b. 3 Mar 1810 d. 26 Feb 1896
12
Mary Elizabeth Campbell
[1.2.3.1.1.1.4.3.3.1.2.1]
b. 28 Aug 1836 d. 16 Mar 1871
12
Charles Sidney Campbell
[1.2.3.1.1.1.4.3.3.1.2.2]
b. Abt 1838
12
Clara Anna Campbell
[1.2.3.1.1.1.4.3.3.1.2.3]
b. Abt 1840
11
George Wait Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.3.1.3]
b. 30 Jun 1818 d. 25 Jun 1884
Sarah Lauretta Cole
b. 7 Mar 1821
12
George Marshall Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.3.1.3.1]
b. 16 Oct 1848 d. 11 Jul 1862
12
Sarah Louise Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.3.1.3.2]
b. 19 May 1850 d. 23 Dec 1881 [
=>
]
12
Clara Esther Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.3.1.3.3]
b. 3 Mar 1852 [
=>
]
12
Walter Sidney Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.3.1.3.4]
b. 1855 d. 31 Mar 1901 [
=>
]
12
Eliza Elizabeth "Lillie Bell" Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.3.1.3.5]
b. 30 Jun 1857 d. 22 Jul 1862
11
Eliza Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.3.1.4]
b. 2 Oct 1817
Stephen Kimball Cutter
b. 12 Mar 1815
12
Frances Eveline Cutter
[1.2.3.1.1.1.4.3.3.1.4.1]
b. 28 Apr 1839 d. 14 Sep 1859
12
Judson Charles Cutter
[1.2.3.1.1.1.4.3.3.1.4.2]
b. 30 Jul 1842
12
Addison Adolphus Cutter
[1.2.3.1.1.1.4.3.3.1.4.3]
b. 20 Apr 1845 d. 26 Jun 1845
12
Addison Adolphus Cutter
[1.2.3.1.1.1.4.3.3.1.4.4]
b. 5 Oct 1846 d. 7 Jul 1906 [
=>
]
12
Ella Eliza Cutter
[1.2.3.1.1.1.4.3.3.1.4.5]
b. 30 Mar 1849
10
Artemas Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.3.2]
b. 17 Jul 1790 d. 1835
Sally Smith
b. Abt 1792
11
Daughter Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.3.2.1]
b. Abt 1806
11
Daughter Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.3.2.2]
b. Abt 1808
11
Daughter Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.3.2.3]
b. Abt 1810
Marcy Pierce
b. 6 Aug 1771 d. 29 Jun 1850
10
Polly Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.3.3]
b. 6 Aug 1795 d. 6 Aug 1802
10
Hiram Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.3.4]
b. 9 Aug 1797 d. 1 Jan 1832
10
Betsey Dagget
[1.2.3.1.1.1.4.3.3.5]
b. 31 Dec 1799 d. 1877
Broughton Knight
b. 25 Feb 1798 d. 4 Feb 1854
11
Allona B Knight
[1.2.3.1.1.1.4.3.3.5.1]
b. Abt 1833 d. 17 Dec 1869
11
Phila Knight
[1.2.3.1.1.1.4.3.3.5.2]
b. Apr 1836
11
George P Knight
[1.2.3.1.1.1.4.3.3.5.3]
b. Aug 1840
10
Hollis Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.3.6]
b. 4 Nov 1802 d. 1882
Flora Jackman
b. Abt 1806
11
Frederick Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.3.6.1]
b. Abt 1826
11
Daughter Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.3.6.2]
b. Abt 1828
10
Lewis Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.3.7]
b. 15 Aug 1804
Harriet Haughton
b. 7 Aug 1807 d. 10 Aug 1866
11
Hiram Sibley Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.3.7.1]
b. 3 Feb 1833 d. 25 Nov 1861
11
Carolina Louisa Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.3.7.2]
b. 7 Jun 1837 d. 14 Feb 1339
11
Henry Talmadge Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.3.7.3]
b. 8 Feb 1840
Mary Eaton
b. 27 Jun 1840 d. 28 Apr 1884
12
Frankie Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.3.7.3.1]
b. 8 Jun 1869 d. 3 Sep 1869
12
William L Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.3.7.3.2]
b. 1 Aug 1871
12
Mary Harriet Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.3.7.3.3]
b. 5 Mar 1884
11
Charles Prentice Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.3.7.4]
b. 5 Oct 1843 d. 14 Jan 1846
11
Charles Lewis Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.3.7.5]
b. 14 Jan 1851 d. 25 Feb 1869
10
Prentis Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.3.8]
b. 25 Aug 1807 d. 29 Oct 1881
10
Mary Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.3.9]
b. 1809 d. 1841
Daniel Pierce
b. 1808
11
Darwin Pierce
[1.2.3.1.1.1.4.3.3.9.1]
b. Abt 1836
11
Horace Pierce
[1.2.3.1.1.1.4.3.3.9.2]
b. Abt 1838
10
Louisa Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.3.10]
b. 10 Dec 1812
Moses Knapp Pratt
b. 1 Jan 1813 d. 15 Mar 1884
11
Frederic Knight Pratt
[1.2.3.1.1.1.4.3.3.10.1]
b. 25 May 1843
Marion B Turnure
b. 1854
12
Frank Hollis Pratt
[1.2.3.1.1.1.4.3.3.10.1.1]
b. 25 Nov 1877
12
Ralph Turnure Pratt
[1.2.3.1.1.1.4.3.3.10.1.2]
b. 22 Apr 1884
9
Nathaniel Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.4]
b. 1766 d. 16 Jun 1852
Electa Roberts
b. 12 Dec 1771 d. 27 Oct 1856
10
Harry Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.4.1]
b. 1793 d. 14 Nov 1869
Julia Crane
b. 1797 d. 25 Dec 1890
11
Julia Ann Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.4.1.1]
b. 29 Jul 1820
11
Harry Crane Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.4.1.2]
b. 24 Dec 1821
Nancy D Whitcomb
b. 2 Oct 1833 d. 28 Nov 1906
12
Milton H Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.4.1.2.1]
b. Mar 1858 d. 1935 [
=>
]
11
Royal Montraville Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.4.1.3]
b. 9 Sep 1823
Adeline L Weeden
b. 25 Jul 1824
12
Emera Montraville Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.4.1.3.1]
b. 1853 d. 1926 [
=>
]
11
Carlos Manson Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.4.1.4]
b. 1 Mar 1827
11
Oscar Fitzwilliam Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.4.1.5]
b. 11 May 1833 d. Aft 1880
Mary Dillocy Brooks
b. 8 Mar 1840 d. Aft 1863
12
Ida M Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.4.1.5.1]
b. 1866
10
Shubael Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.4.2]
b. 1797
10
Orville Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.4.3]
b. 1799
10
Celista Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.4.4]
b. 1801 d. 6 Jan 1862
10
Phineas Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.4.5]
b. 1802
10
Phinehas Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.4.6]
b. 9 Aug 1802 d. 30 Oct 1877
Emeline Boynton
b. 29 Jul 1807 d. 6 Feb 1881
11
Pemelia Anne Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.4.6.1]
b. 17 Apr 1829 d. 5 Jul 1883
11
Hallis Boynton Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.4.6.2]
b. 28 Dec 1830 d. 14 Feb 1835
11
Lillian Sarah Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.4.6.3]
b. 3 Dec 1832 d. 20 Oct 1861
George James
b. 3 Apr 1827 d. 22 May 1902
12
Ellen Eudora James
[1.2.3.1.1.1.4.3.4.6.3.1]
b. 5 May 1851 d. 28 Jan 1908
12
Myra Louisa James
[1.2.3.1.1.1.4.3.4.6.3.2]
b. 5 Oct 1852 d. 15 Jul 1926 [
=>
]
12
Sarah Lillian James
[1.2.3.1.1.1.4.3.4.6.3.3]
b. 31 Jan 1856 d. 1921
11
May Miriah Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.4.6.4]
b. 10 Feb 1836
11
Mary M Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.4.6.5]
b. 10 Feb 1836
11
Harriet B Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.4.6.6]
b. 11 Sep 1837
11
Joseph Nathaniel Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.4.6.7]
b. 17 Nov 1839 d. 24 Mar 1902
11
Emeline Arethusa Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.4.6.8]
b. 25 Sep 1841 d. 15 Oct 1910
George James
b. 3 Apr 1827 d. 22 May 1902
12
Rosa Beatrice James
[1.2.3.1.1.1.4.3.4.6.8.1]
b. 29 May 1866 [
=>
]
12
Edward James
[1.2.3.1.1.1.4.3.4.6.8.2]
b. 1871 d. 1875
11
Loretta Lamar Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.4.6.9]
b. 27 May 1844
11
Ellen Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.4.6.10]
b. 1 Nov 1846
11
Abbie Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.4.6.11]
b. 17 Apr 1848
10
Nathaniel Daggett, Jr
[1.2.3.1.1.1.4.3.4.7]
b. 1804
10
Alpheus Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.4.8]
b. 1807
10
Samuel Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.4.9]
b. 1810
10
Philarmon Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.4.10]
b. 1812
10
Amos Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.4.11]
b. 1814
10
Electa Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.4.12]
b. 1816
9
Susan Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.5]
b. Abt 1768
John Rice
b. 1764 d. 1841
10
Nancy Rice
[1.2.3.1.1.1.4.3.5.1]
b. 1789
+
Luther Denison
b. Abt 1787
+
Jeremiah Robbins
b. Abt 1785
10
John Rice
[1.2.3.1.1.1.4.3.5.2]
b. 1791 d. Aft 1824
Eliza Burke
b. 29 May 1797
11
Ebed Burke Rice
[1.2.3.1.1.1.4.3.5.2.1]
b. Abt 1824
10
Mary "Polly" Rice
[1.2.3.1.1.1.4.3.5.3]
b. 1793 d. 1854
Samuel Nichols
b. 1772
11
Caroline E Nichols
[1.2.3.1.1.1.4.3.5.3.1]
b. 1818 d. 3 Aug 1903
William Storer
b. 1817
12
Ellen Maria Storer
[1.2.3.1.1.1.4.3.5.3.1.1]
b. 2 Jun 1847 d. 22 Nov 1896
12
Eliza M Storer
[1.2.3.1.1.1.4.3.5.3.1.2]
b. 20 Jun 1847 d. Bef 1855
12
William Nichols Storer
[1.2.3.1.1.1.4.3.5.3.1.3]
b. 16 Sep 1849 d. 7 Jun 1909 [
=>
]
12
Henry Johnson Storer
[1.2.3.1.1.1.4.3.5.3.1.4]
b. 28 Aug 1860 d. 1 May 1935
10
Lewis Rice
[1.2.3.1.1.1.4.3.5.4]
b. 1796 d. 1835
10
Louisa Rice
[1.2.3.1.1.1.4.3.5.5]
b. 1798
+
Gilman Esty
10
Fannie Rice
[1.2.3.1.1.1.4.3.5.6]
b. 1800 d. Aft 1821
Tyler Curtis Knight
b. 23 Aug 1797 d. 22 Apr 1855
11
Lucretia Knight
[1.2.3.1.1.1.4.3.5.6.1]
d. 22 Apr 1855
+
Charles A Towne
10
Lucinda Rice
[1.2.3.1.1.1.4.3.5.7]
b. 1802
+
John Bryant
b. Abt 1800
10
Horace Rice
[1.2.3.1.1.1.4.3.5.8]
b. 1804
10
Emily Rice
[1.2.3.1.1.1.4.3.5.9]
b. 1809
+
Thurman Richardson
b. Abt 1805
10
Susan Rice
[1.2.3.1.1.1.4.3.5.10]
b. 1811
+
Calvin B Meade
b. Abt 1807
10
George Rice
[1.2.3.1.1.1.4.3.5.11]
b. 1807
+
Caroline Estey
b. 27 Dec 1801
9
Hannah Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.6]
b. 1770
+
Horton
9
Sarah Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.7]
b. Abt 1772
9
Amos Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.8]
b. Abt 1772
9
Daughter Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.3.9]
b. Abt 1774
+
William Ide
8
Arthur Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4]
b. 30 Jan 1730 d. 23 Aug 1775
Mehitable King
b. 8 May 1731 d. 13 Mar 1809
9
Arthur Daggett, Jr
[1.2.3.1.1.1.4.4.1]
b. 23 Apr 1751 d. 25 Aug 1835
Lucy Cutler
b. 17 Apr 1749 d. 23 Feb 1813
10
Arthur Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.1]
b. 13 Sep 1774 d. 11 Jan 1855
Azuba Haskell
b. 8 Mar 1768
11
Arthur Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.1.1]
b. 4 Apr 1803
11
Freeman Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.1.2]
b. 20 Jun 1807
Calista Ingalls
b. 9 Jan 1809 d. 30 Aug 1886
12
George Dagget
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.1.2.1]
b. 18 Sep 1835 d. 1885
10
Stephen Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.2]
b. 7 Mar 1776 d. 22 Dec 1810
Mary Doty
b. 13 Aug 1781 d. 15 Mar 1855
11
Lucy Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.2.1]
b. 28 Jan 1805
Alphena Bliss
b. 13 Nov 1802 d. 1 Feb 1844
12
Catharine Amelia Bliss
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.2.1.1]
b. 31 Aug 1828 d. 12 Feb 1892 [
=>
]
12
Caroline Elizabeth Bliss
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.2.1.2]
b. 10 Sep 1840 [
=>
]
11
Catharine Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.2.2]
b. 16 Jan 1807 bur. 1887
Levi Robinson
b. 18 Sep 1803 d. 7 Sep 1863
12
Joel Emery Robinson
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.2.2.1]
b. 18 Feb 1834 d. 28 Jul 1863
12
Julius Robinson
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.2.2.2]
b. 9 Mar 1836 [
=>
]
12
Otis Vinton Robinson
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.2.2.3]
b. 25 Jul 1838 d. 15 Sep 1863
12
Mary Cherville Robinson
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.2.2.4]
b. 24 Aug 1845 d. 28 Nov 1922 [
=>
]
11
James Sullivan Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.2.3]
b. 20 Sep 1808
+
Elisabeth Vinton
b. Jul 1812 d. 12 Jun 1850
Fidelia Pratt
b. 1818
12
Abbie Elizabeth Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.2.3.1]
b. 22 Sep 1851
11
Marietta Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.2.4]
b. 9 Sep 1809 d. 26 Oct 1840
10
John Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.3]
b. 22 Dec 1777 d. 26 Aug 1820
Loruhanah Nealy
b. 5 Aug 1782 d. 1814
11
Nealy Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.3.1]
b. 17 Apr 1803 d. 24 Aug 1824
11
Katherine Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.3.2]
b. 16 Jan 1807 d. 1887
Ebenezer Chapin
b. 1 May 1800 d. 29 Jan 1874
12
Nealy Adolphus Chapin
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.3.2.1]
b. 28 Jan 1828 d. 30 Mar 1899 [
=>
]
12
Jane Chapin
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.3.2.2]
b. 1833
12
Patrick Henry Chapin
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.3.2.3]
b. 22 Aug 1834 d. 1886 [
=>
]
12
Mary Ann "Rene" Chapin
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.3.2.4]
b. 4 Nov 1836 d. Aft 1889
12
John Ebenezer Chapin
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.3.2.5]
b. 10 Mar 1840 [
=>
]
12
Flora Ann Chapin
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.3.2.6]
b. Abt 1842
12
James Chapin
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.3.2.7]
b. Abt 1844 [
=>
]
12
Andrew Gregg Chapin
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.3.2.8]
b. 13 Sep 1845 d. 10 Apr 1846
11
John Scott Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.3.3]
b. 22 Feb 1808 d. 14 Jan 1890
+
Sarah Chapin
b. Abt 1810 d. 8 Aug 1865
11
Orpha Edson Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.3.4]
b. 24 May 1810 d. 9 Jun 1875
+
Willis Edson
b. Abt 1810
Ira Woods
b. 2 Jan 1792 d. 4 Aug 1851
12
Clarissa E Woods
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.3.4.1]
b. May 1840 d. 10 Sep 1908 [
=>
]
12
Nealy Chapin Woods
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.3.4.2]
b. 12 Jun 1842 d. 23 May 1918 [
=>
]
12
Phebe Woods
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.3.4.3]
b. Abt 1844 d. Bef 1908
12
Emily Woods
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.3.4.4]
b. Abt 1846 d. Bef 1908
12
Orpha Woods
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.3.4.5]
b. 21 Apr 1850 d. 17 Sep 1938 [
=>
]
Abigail Durfee
b. 1780 d. Aug 1820
11
Stephen Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.3.5]
b. 11 Oct 1816 d. 1833
11
Simeon Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.3.6]
b. 14 Aug 1818 d. 23 Jun 1898
Martha McCrary Rea
b. 30 Mar 1822 d. 5 Jan 1907
12
Edmond M Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.3.6.1]
b. 1 Jan 1840 d. 20 Oct 1866
12
Louisa Jane Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.3.6.2]
b. 24 Jul 1841 d. 3 Dec 1863 [
=>
]
12
Elizabeth M Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.3.6.3]
b. 8 Jan 1844 d. Sep 1844
12
Simeon Taylor Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.3.6.4]
b. 22 Dec 1846 d. 18 Sep 1935 [
=>
]
12
John Scott Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.3.6.5]
b. Abt 1848 d. Mar 1850
12
Silas Clark Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.3.6.6]
b. 13 May 1852 d. 1930 [
=>
]
12
Martha Salena Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.3.6.7]
b. 26 Aug 1859 d. 5 Jan 1902
12
Frank Smith Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.3.6.8]
b. 18 May 1864 d. 1902 [
=>
]
10
Simeon Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.4]
b. 11 Jun 1779 d. 25 Jan 1823
+
Sallie Putnam
b. 1782
10
Polly Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.5]
b. 14 Feb 1781 d. 1 Nov 1813
Amasa Bancroft
b. 19 Mar 1778 d. 6 Feb 1812
11
Lucy Bancroft
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.5.1]
b. 30 Mar 1802
Banabus Hammett Snow
d. 31 May 1873
12
Polly Bancroft Snow
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.5.1.1]
b. 28 Nov 1823 d. 7 Sep 1860 [
=>
]
12
Kate Daggett Snow
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.5.1.2]
b. 11 Oct 1826
12
Emaline Snow
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.5.1.3]
b. 20 Sep 1829
12
Avis Snow
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.5.1.4]
b. 17 Mar 1832
11
Nancy Bancroft
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.5.2]
b. 1804
11
Cornelius Watrous Bancroft
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.5.3]
b. 1808 d. 22 Jan 1856
+
Lucy B Howard
b. 1808
11
Carlos Bancroft
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.5.4]
b. 20 Mar 1809 d. 24 Oct 1876
Mary E Johnston
b. 4 Jul 1813 d. 15 Sep 1856
12
Jane Sophia Bancroft
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.5.4.1]
b. 1 Oct 1841
12
Arthur Daggett Bancroft
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.5.4.2]
b. 29 Aug 1843 [
=>
]
12
Carlos Amasa Bancroft
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.5.4.3]
b. 15 Sep 1845 d. 1846
12
Charles Eastman Bancroft
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.5.4.4]
b. 23 Apr 1848 d. 6 Aug 1848
12
Carlos Johnston Bancroft
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.5.4.5]
b. 18 May 1852 d. 6 Aug 1863
12
Frederick Wallace Bancroft
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.5.4.6]
b. 15 Sep 1855
11
Amasa Bancroft
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.5.5]
b. 4 Mar 1811
10
Cate Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.6]
b. 4 Apr 1786
10
Lucy Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.7]
b. 27 Sep 1789
10
Mehitable Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.1.8]
b. 1793 d. 14 Aug 1844
9
Mehetabel Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.2]
b. 10 Oct 1752 d. 20 Apr 1834
Jonathon Rich
b. 20 Jul 1747 d. 28 Aug 1828
10
Reuben Rich
[1.2.3.1.1.1.4.4.2.1]
b. 26 Apr 1775
10
Simeon Rich
[1.2.3.1.1.1.4.4.2.2]
b. 6 Mar 1780 d. 11 Sep 1855
Patty Ward
b. 19 Dec 1779
11
Gibert Rich
[1.2.3.1.1.1.4.4.2.2.1]
b. 29 Nov 1806
Huldah Gould Lamson
b. 26 Oct 1815 d. 20 Jan 1845
12
Arthur Rich
[1.2.3.1.1.1.4.4.2.2.1.1]
b. 27 Dec 1841
12
Alonzo Gilbert Rich
[1.2.3.1.1.1.4.4.2.2.1.2]
b. 20 Oct 1843
11
Loisa Rich
[1.2.3.1.1.1.4.4.2.2.2]
b. Bef 1809
+
Lewis Blood
b. Abt 1809
11
Diantha Rich
[1.2.3.1.1.1.4.4.2.2.3]
b. 1 Jun 1817
Robert Craig
b. 30 Oct 1805
12
Esther Craig
[1.2.3.1.1.1.4.4.2.2.3.1]
b. Abt 1844
12
Martha Craig
[1.2.3.1.1.1.4.4.2.2.3.2]
b. Abt 1847
12
Emily Lorinda Craig
[1.2.3.1.1.1.4.4.2.2.3.3]
b. 28 Apr 1851
12
Martha L Craig
[1.2.3.1.1.1.4.4.2.2.3.4]
b. 9 Jun 1860 [
=>
]
11
Erastus Rich
[1.2.3.1.1.1.4.4.2.2.4]
b. Sep 1809
11
Lucetta Rich
[1.2.3.1.1.1.4.4.2.2.5]
b. 8 Mar 1820 d. Aft 1870
+
Cyrus Lamb
b. 2 Nov 1818 d. 12 Apr 1882
11
Louisa Rich
[1.2.3.1.1.1.4.4.2.2.6]
b. 6 Apr 1812
11
Lorinda Rich
[1.2.3.1.1.1.4.4.2.2.7]
b. 3 Nov 1814 d. Sep 1844
10
Arthur Rich
[1.2.3.1.1.1.4.4.2.3]
b. 13 Oct 1777
+
Ruby Titus
b. Abt 1781
10
Cynthia Rich
[1.2.3.1.1.1.4.4.2.4]
b. Abt 1779
+
Dexter Carbin
b. Abt 1775
10
Jonathan Rich, Jr
[1.2.3.1.1.1.4.4.2.5]
b. 19 Nov 1782
10
Paul Rich
[1.2.3.1.1.1.4.4.2.6]
b. 16 Aug 1785
10
Barnabas Rich
[1.2.3.1.1.1.4.4.2.7]
b. 13 Oct 1787
+
Lucy Nichols
b. 17 May 1796 d. 20 Feb 1868
9
Simeon Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.3]
b. 7 Mar 1757 d. 9 May 1819
Anna Dean
b. 1759 d. 9 May 1819
10
Nancy Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.1]
b. Abt 1779
+
Amos Putney
b. 10 Feb 1789
10
Simeon Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.2]
b. 1780 d. 17 Jun 1854
Susan Towle
b. 1795 d. 15 Jul 1874
11
Elias Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.2.1]
b. 1816
+
Mary A
b. 1825
11
Lydia A Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.2.2]
b. 1819
11
Susan T Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.2.3]
b. 1823 d. 22 Oct 1907
11
Mary Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.2.4]
b. 1825 d. 26 May 1863
+
Benson Banton
b. Abt 1823
11
Simeon Orval Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.2.5]
b. 1827
Mary Putnam
b. 1828
12
George Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.2.5.1]
b. 30 Aug 1847
12
Homer Putnam Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.2.5.2]
b. 1850 d. 30 May 1924 [
=>
]
12
Mary J Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.2.5.3]
b. 1852 d. 1912
12
Morris Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.2.5.4]
b. 1854 [
=>
]
12
Gilman Towle Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.2.5.5]
b. 1859 d. 13 Nov 1930
12
Nina Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.2.5.6]
b. Abt 1860
12
Susan Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.2.5.7]
b. 8 Apr 1862
+
Elizabeth King
b. Abt 1825
10
Sally Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.3]
b. 1782
10
Son Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.4]
b. Abt 1784
10
Nathaniel Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.5]
b. 12 Jul 1785 d. Abt 1827
Maltilda Farwell
b. 17 Jun 1794 d. 4 Oct 1883
11
Catherine Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.5.1]
b. 20 Jun 1811 d. 19 Nov 1861
+
Henry John Richardson
c. 18 Jan 1809
11
Lorenzo Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.5.2]
b. 14 Feb 1813 d. 24 Nov 1889
Henrieta Chipman
b. 5 Oct 1817 d. 12 May 1847
12
John F Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.5.2.1]
b. 25 Feb 1837 d. 15 Feb 1897 [
=>
]
12
Hannah Matilda Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.5.2.2]
b. 15 Dec 1838 d. 3 Jan 1905 [
=>
]
12
Jane Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.5.2.3]
b. 5 Aug 1841 d. 3 Sep 1842
12
Melissa Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.5.2.4]
b. 31 May 1843 d. Aft 1905
12
Helen May Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.5.2.5]
b. 27 Apr 1845 [
=>
]
12
Sylvester Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.5.2.6]
b. 30 Apr 1847 d. 30 Apr 1847
Eliza J Jones
b. 4 Mar 1830 d. 1890
12
George Jones Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.5.2.7]
b. 22 May 1848 d. 26 Feb 1849
12
Francis J Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.5.2.8]
b. 1 Oct 1849 d. Aft 1905
12
Sarah A Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.5.2.9]
b. 2 May 1851 d. 1 Dec 1852
12
Nathaniel Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.5.2.10]
b. 29 May 1853 d. 3 Sep 1934 [
=>
]
12
Alice G Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.5.2.11]
b. 12 Jun 1855
Mary Ann Laken
b. 10 Nov 1813 d. 3 Jun 1905
12
James A Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.5.2.12]
b. 27 Jan 1860 d. 19 Oct 1934 [
=>
]
11
John Farwell Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.5.3]
b. 2 Apr 1816 d. 21 Jun 1899
Elizabeth Maria Burdick
b. 16 Sep 1821 d. 28 Mar 1899
12
Maria Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.5.3.1]
b. 1842 d. Abt 1847
12
Byron Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.5.3.2]
b. 1844
12
Mary Jane Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.5.3.3]
b. 1845
12
Edwin Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.5.3.4]
b. 1847
12
Sarah Elizabeth Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.5.3.5]
b. 2 Jun 1849 d. 28 Aug 1937 [
=>
]
12
Catherine Minerva Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.5.3.6]
b. 8 Feb 1852 d. 1930 [
=>
]
12
Ida Matilda Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.5.3.7]
b. 9 Jun 1854 d. 13 Apr 1932 [
=>
]
12
John Burdick Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.5.3.8]
b. 15 Oct 1854 d. 2 Nov 1931 [
=>
]
12
James Malcom Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.5.3.9]
b. 30 Mar 1859 d. 11 Nov 1919
12
Emma Adeline Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.5.3.10]
b. 18 Nov 1861 d. 26 Oct 1931 [
=>
]
12
Alvan Nathaniel Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.5.3.11]
b. Jul 1864 d. 22 Feb 1903
11
Derius Dagget
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.5.4]
b. 9 Jan 1819 d. 30 Jan 1819
11
Sarah Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.5.5]
b. 31 Jul 1822 d. May 1922
11
Sophia Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.5.6]
b. 9 Oct 1825
+
James Monroe Sumner
b. 17 Mar 1817 d. 13 Jun 1873
10
Caleb C Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.6]
b. Abt 1790 d. 23 Dec 1879
10
Artemas Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.7]
b. 17 Jul 1790
10
Mary Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.8]
b. 10 Nov 1795 d. 18 Aug 1864
Henry C Hooker
b. 5 Jul 1791 d. 17 Mar 1885
11
Amelia Prentice Hooker
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.8.1]
b. 26 Aug 1817 d. 23 Dec 1817
11
Julia Worthington Hooker
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.8.2]
b. 15 Nov 1818 d. 14 Oct 1915
Henry Mason Jones
b. 24 Jul 1811 d. 7 Jul 1886
12
Henry Abbott Jones
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.8.2.1]
b. 29 Mar 1845
12
Charles Armest Jones
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.8.2.2]
b. 25 Feb 1848
12
Frederick Hooker Jones
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.8.2.3]
b. 30 Nov 1866 [
=>
]
11
George Prentice Hooker
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.8.3]
b. 31 May 1820 d. 1912
Lucretia Jane Ashcraft
b. 1822 d. 25 Feb 1897
12
Della Louise Hooker
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.8.3.1]
b. 23 Jul 1844
12
Augusta R Hooker
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.8.3.2]
b. 12 Oct 1851 [
=>
]
12
George Utley Hooker
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.8.3.3]
b. 9 Oct 1856 d. 13 Jan 1858
12
Cora Jane Hooker
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.8.3.4]
b. 10 Jan 1859
11
Charles Gay Hooker
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.8.4]
b. 12 Nov 1822 d. 18 Nov 1905
Maria Celia Osgood
b. 3 Sep 1836
12
Charles Osgood Hooker
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.8.4.1]
b. 10 Aug 1860 [
=>
]
12
Robert Gay Hooker
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.8.4.2]
b. 13 Jul 1862
12
Jennie May Hooker
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.8.4.3]
b. 3 Jul 1864
12
Bessie Augusta Hooker
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.8.4.4]
b. 31 Dec 1868
12
Florence Gertrude Hooker
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.8.4.5]
b. 1 Apr 1871
11
Ansen Carey Hooker
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.8.5]
b. 2 Sep 1825 d. 4 Jul 1832
11
Henry Clay Hooker
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.8.6]
b. 10 Jan 1828 d. 5 Dec 1907
Elizabeth Tewksbury Rockwell
b. 23 Dec 1837 d. 14 Mar 1915
12
Ida M Hooker
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.8.6.1]
b. 3 May 1858
12
Edwin R Hooker
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.8.6.2]
b. 27 Feb 1861
12
Joseph M Hooker
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.8.6.3]
b. 4 Sep 1863
11
Almira Ann Hooker
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.8.7]
b. 28 May 1830 d. 5 Jul 1904
Isaiah Hall Nutting
b. 14 Dec 1824 d. 1 Dec 1865
12
Frederic Joseph Nutting
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.8.7.1]
b. 22 Nov 1854 [
=>
]
12
Herbert Hooker Nutting
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.8.7.2]
b. 22 Jul 1859 d. 7 Jul 1947 [
=>
]
12
Minnie Mariah Nutting
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.8.7.3]
b. 4 Aug 1861
11
Minerva Sophia Hooker
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.8.8]
b. 11 Sep 1832 d. 13 Nov 1921
Robert Turnbull Brown
b. 1842 d. 19 Nov 1878
12
Robert Turnbull Brown
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.8.8.1]
b. 31 Jul 1868
12
Minnie Isabel Brown
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.8.8.2]
b. 19 Sep 1871 d. 22 Sep 1871
12
Edith Hooker Brown
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.8.8.3]
b. 1 Jul 1872 d. 15 May 1873
+
Edwin Ruthven Robertson
b. 1828 d. 4 Apr 1902
11
Ansen Carey Hooker
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.8.9]
b. 1 May 1835 d. 8 Nov 1915
11
John Daggett Hooker
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.8.10]
b. 10 May 1838 d. 24 May 1911
Katharine Muzzy Putnam
b. 2 May 1849
12
Laurence Whitney Hooker
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.8.10.1]
b. 14 Jun 1873 d. 11 Dec 1894
12
Marian Osgood Hooker
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.8.10.2]
b. 15 Jul 1875
11
Mary Rosella Hooker
[1.2.3.1.1.1.4.4.3.8.11]
b. 12 Jan 1841 d. May 1925
+
Nicholas H. Smith
b. 1839
9
Gideon Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.4]
b. 21 Dec 1759 d. 27 Aug 1838
Elizabeth Pratt
b. 22 Jul 1759 d. 1822
10
Gardner Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.4.1]
b. 12 Oct 1788 d. Oct 1843
Eunice White
b. 23 Oct 1787 d. 15 Jun 1833
11
Sophronia Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.4.1.1]
b. 15 Jul 1812 d. 14 Oct 1888
+
Amos Stoddard
11
Diana Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.4.1.2]
b. Dec 1814 d. 1866
11
Eunice Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.4.1.3]
b. Dec 1816 d. 1841
11
Elizabeth Ann Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.4.1.4]
b. 4 Jul 1818
11
William Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.4.1.5]
b. 1821 d. May 1835
11
Gardner Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.4.1.6]
b. Abt 1823
11
Arthur Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.4.1.7]
b. Abt 1825
11
Harriet Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.4.1.8]
b. Apr 1827 d. Oct 1876
Hays G. Luce
b. 1818
12
Emma Melissa Luce
[1.2.3.1.1.1.4.4.4.1.8.1]
b. Abt 1849
12
Sarah Luce
[1.2.3.1.1.1.4.4.4.1.8.2]
b. Abt 1851
12
Harriet Luce
[1.2.3.1.1.1.4.4.4.1.8.3]
b. Abt 1853
12
John Luce
[1.2.3.1.1.1.4.4.4.1.8.4]
b. 18 May 1854 d. 4 Feb 1922 [
=>
]
12
Moses Luce
[1.2.3.1.1.1.4.4.4.1.8.5]
b. Abt 1857
12
Emily Luce
[1.2.3.1.1.1.4.4.4.1.8.6]
b. Abt 1859
11
Ester Smith Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.4.1.9]
b. 27 Sep 1829
Edward Henry Gleason
b. 12 Dec 1823 d. 24 Nov 1889
12
Rollin Henry Gleason
[1.2.3.1.1.1.4.4.4.1.9.1]
b. 24 Dec 1854 d. 28 Sep 1918 [
=>
]
12
Irene May Gleason
[1.2.3.1.1.1.4.4.4.1.9.2]
b. 3 Feb 1858 d. 24 Feb 1858
12
Emie Bell Gleason
[1.2.3.1.1.1.4.4.4.1.9.3]
b. 10 May 1860 d. 1 Apr 1886
12
Stanley Gleason
[1.2.3.1.1.1.4.4.4.1.9.4]
b. 31 Jan 1863 d. 30 Mar 1863
12
Adrienna Gleason
[1.2.3.1.1.1.4.4.4.1.9.5]
b. 1 May 1864
12
Grace Gleason
[1.2.3.1.1.1.4.4.4.1.9.6]
b. 8 Oct 1866 d. 12 Aug 1868
12
Helen Gleason
[1.2.3.1.1.1.4.4.4.1.9.7]
b. 13 Nov 1869 d. 30 Jun 1883
12
Maud Gleason
[1.2.3.1.1.1.4.4.4.1.9.8]
b. 28 Feb 1873 d. 11 Aug 1874
12
Claud Gleason
[1.2.3.1.1.1.4.4.4.1.9.9]
b. 28 Feb 1873
11
Rollin Mallory Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.4.1.10]
b. 22 Feb 1831
+
Maggie Curry
b. 19 Mar 1851 d. 21 Mar 1877
+
Lizzie Mabel Hinds
b. 12 Apr 1863
10
William King Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.4.2]
b. 24 Aug 1792 d. 6 Feb 1862
+
Betsy Johnson
b. 20 Sep 1791 d. 6 Nov 1835
10
Nancy Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.4.3]
b. 1793
10
Harvey Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.4.4]
b. 1797
10
Gideon Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.4.5]
b. 1800
9
Betty Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.5]
b. 3 Feb 1763 d. 28 Jul 1829
Thomas Todd
b. 17 Nov 1760 d. 20 Nov 1848
10
Billy Todd
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.1]
b. 15 Jul 1783 d. 1871
10
Lavina Todd
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.2]
b. 1 Sep 1785 d. Mar 1835
10
Orinda Todd
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.3]
b. 1 Sep 1787 d. 12 Jun 1872
Jeremiah Dewey
b. 31 Jan 1788 d. 29 Jul 1849
11
Harvey Dewey
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.3.1]
b. 1814
11
Elizabeth "Betsey" Dewey
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.3.2]
b. 6 Apr 1814 d. 6 Apr 1848
William Van Benschoten
b. 28 Dec 1806 d. 1 Dec 1863
12
Eulalia Carlin Van Benschoten
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.3.2.1]
b. 9 Feb 1834 d. 9 Jul 1898 [
=>
]
12
William W Van Benschoten
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.3.2.2]
b. 12 Mar 1836 d. 15 Sep 1837
12
Marion E Van Benschoten
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.3.2.3]
b. 14 Oct 1839 d. 25 Jul 1849
12
Helen Marr Van Benschoten
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.3.2.4]
b. 28 Feb 1841 d. 26 Jul 1849
12
Frank Van Benschoten
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.3.2.5]
b. 17 Jul 1844 d. 20 Sep 1847
12
Elizabeth A Van Benschoten
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.3.2.6]
b. 24 Jan 1846 d. 8 Sep 1846
12
Elmore T Van Benschoten
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.3.2.7]
b. 21 Jul 1847 d. Abt 1848
11
Hiram T Dewey
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.3.3]
b. 13 Jul 1816 d. 25 May 1898
Susan Lanfley Stapleford
b. 28 Dec 1818 d. 25 May 1898
12
Jeremiah Todd Dewey
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.3.3.1]
b. 7 Sep 1841 [
=>
]
12
George Eugene Dewey
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.3.3.2]
b. 19 Dec 1843 [
=>
]
12
Mary Elizabeth Dewey
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.3.3.3]
b. 17 Mar 1846 [
=>
]
12
Susan Arabella Dewey
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.3.3.4]
b. 26 Jul 1848 [
=>
]
12
Hiram Stapleford Dewey
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.3.3.5]
b. 3 Jul 1857 bur. 12 May 1934 [
=>
]
12
William Henry Dewey
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.3.3.6]
b. 1 Jan 1863 d. Dec
11
Washington Dewey
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.3.4]
b. 10 Sep 1818 d. 16 Mar 1896
Alvina Webster
b. 23 May 1818 d. 22 Oct 1871
12
Rosa M Dewey
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.3.4.1]
b. Abt 1844 [
=>
]
12
Royal E Dewey
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.3.4.2]
b. 25 Aug 1849 d. 27 Dec 1907 [
=>
]
12
George Washington Dewey
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.3.4.3]
b. Abt 1853
12
Kate L Dewey
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.3.4.4]
b. Abt 1856
11
Royal Dewey
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.3.5]
b. 1820
11
Orinda Dewey
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.3.6]
b. 1822
10
Diantha Todd
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.4]
b. 1 May 1791 d. 27 Dec 1824
10
Elmer Todd
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.5]
b. 16 Jun 1793 d. 13 Oct 1812
10
Relief Todd
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.6]
b. 11 Mar 1798 d. 19 Oct 1885
Joseph Moulton
b. 7 Feb 1798 d. 10 Feb 1873
11
Anne Moulton
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.6.1]
b. 31 Mar 1822
Charles Cowles
b. 19 Dec 1817 d. 28 Feb 1869
12
Joseph Moulton Cowles
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.6.1.1]
b. 30 Jul 1848 d. 31 Dec 1850
12
Harriet Anne Cowles
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.6.1.2]
b. 1 Sep 1850
12
Martha Chase Cowles
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.6.1.3]
b. 3 Nov 1852
12
Chester William Cowles
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.6.1.4]
b. 7 Dec 1854 d. 7 May 1858
12
Charlotte Cowles
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.6.1.5]
b. 27 Jan 1859 [
=>
]
12
Charles Albert Cowles
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.6.1.6]
b. 12 May 1862 [
=>
]
11
James Thompson Moulton
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.6.2]
b. 1 Nov 1823
Louisa J Williams
b. 28 Dec 1822 d. 12 Apr 1871
12
Catherine Elizabeth Moulton
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.6.2.1]
b. 26 Jan 1852
12
Joseph Moulton
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.6.2.2]
b. 5 Feb 1854 [
=>
]
12
David W Moulton
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.6.2.3]
b. 9 Nov 1855 d. 27 Jun 1937
12
Abbie Louisa Moulton
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.6.2.4]
b. 1 May 1857
12
James Thompson Moulton
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.6.2.5]
b. 18 Mar 1859 d. 10 Jul 1859
12
Anna Moulton
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.6.2.6]
b. 10 Apr 1860 d. 13 May 1862
12
Annette Frances Moulton
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.6.2.7]
b. 21 Nov 1862
12
John Franklin Moulton
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.6.2.8]
b. 1 Jan 1866 d. 15 Aug 1894
+
Helen Ewell
b. 20 Jul 1822 d. 27 Jan 1909
11
Charles Henry Moulton
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.6.3]
b. 6 Feb 1829
Lydia S Wiley
b. Abt 1830
12
Mary Ellen Moulton
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.6.3.1]
b. 20 Apr 1856
11
John Todd Moulton
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.6.4]
b. 7 Aug 1838 d. 10 Feb 1873
Sarah Frances Sweetser
b. 20 Jun 1841 d. 24 Apr 1918
12
Annie Coules Moulton
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.6.4.1]
b. 5 Dec 1867 [
=>
]
12
Albert S Moulton
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.6.4.2]
b. 31 Jul 1872 d. 15 Sep 1943 [
=>
]
12
Robert Elmer Moulton
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.6.4.3]
b. 15 Jan 1876 d. 3 Sep 1876
12
Elizabeth Jane Moulton
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.6.4.4]
b. 28 Aug 1878
12
Bessie Jane Moulton
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.6.4.5]
b. 28 Aug 1878
11
Walter Scott Moulton
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.6.5]
b. 9 Aug 1840 d. 17 Jun 1874
Rosalinda E. Wilson
b. May 1848
12
Relief Esther Moulton
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.6.5.1]
b. 14 Jun 1868 [
=>
]
10
Alanson Todd
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.7]
b. 5 Sep 1800 d. 13 Jul 1882
Lydia Wheeler
b. 24 Oct 1800 d. 14 Oct 1877
11
Elmor Todd
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.7.1]
b. 27 Feb 1828 d. 16 Jul 1829
11
Son Todd
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.7.2]
b. 4 Jul 1829 d. 4 Jul 1829
11
Cornelia Todd
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.7.3]
b. 15 May 1831 d. 14 Mar 1877
+
Julius Leonard Stacey
b. 16 Oct 1826 d. 7 Nov 1902
11
Cyrus Wheeler Todd
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.7.4]
b. 5 Jun 1833 d. 25 Dec 1903
Louisa Charlotte Hoese
d. 8 Mar 1926
12
William Irving Todd
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.7.4.1]
b. 25 Aug 1873 d. 1 Dec 1942
12
Helen May Todd
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.7.4.2]
b. 3 May 1875 [
=>
]
12
Frank Hyrum Todd
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.7.4.3]
b. 10 Sep 1883 d. 28 Jun 1958 [
=>
]
11
Hiram Todd
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.7.5]
b. 30 Apr 1836 d. 20 Jun 1840
11
Helen Mar Todd
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.7.6]
b. 1 Jul 1838 d. 27 Jan 1923
10
Charles Todd
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.8]
b. 27 Sep 1802 d. 8 Apr 1804
10
Hiram Todd
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.9]
b. 18 Nov 1795 d. 11 Jul 1849
Lydia Church
b. 8 Jan 1802 d. 26 Dec 1871
11
Caroline Todd
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.9.1]
b. 26 Feb 1830 d. Mar 1833
11
Frances Todd
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.9.2]
b. 12 Sep 1832
Rodney S Bowen
b. 1831 d. 3 Dec 1864
12
Mary C Bowen
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.9.2.1]
b. Abt 1852
12
Rodney S Bowen
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.9.2.2]
b. Abt 1854
12
Albert W Bowen
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.9.2.3]
b. Abt 1856
12
Martha Bowen
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.9.2.4]
b. Abt 1858
11
Hiram Church Todd
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.9.3]
b. 26 Jun 1835
Sarah D Barnard
b. 2 Jan 1842 d. 2 Oct 1878
12
Maggie Barnard Todd
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.9.3.1]
b. 21 Nov 1862 d. 25 Aug 1881
12
Walter Wilson Todd
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.9.3.2]
b. 22 May 1865 [
=>
]
12
Grace Lydia Todd
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.9.3.3]
b. 18 Oct 1868 d. 30 Mar 1872
12
Lucia May Todd
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.9.3.4]
b. 4 May 1873 d. 11 Mar 1874
12
Lillian Belle Todd
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.9.3.5]
b. 8 Dec 1874 d. 7 Aug 1876
12
Frank Ransom Todd
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.9.3.6]
b. 1 Mar 1877 d. 27 Sep 1877
11
Martha Todd
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.9.4]
b. 21 Sep 1837 d. 1 Sep 1847
11
Walter Wilson Todd
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.9.5]
b. 27 Feb 1840 d. 18 Oct 1899
Azenath M Gerard
b. 9 Nov 1844 d. 16 Dec 1895
12
Laura Todd
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.9.5.1]
b. 4 Oct 1869
12
Church Gerard Todd
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.9.5.2]
b. 15 Jan 1871
12
Hiram Eugene Todd
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.9.5.3]
b. 10 Sep 1874
11
Edgar Todd
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.9.6]
b. Abt 1842
10
Solomon Todd
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.10]
b. 15 Oct 1804 d. 17 Oct 1832
10
Betsey Todd
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.11]
b. 8 Nov 1806
Austin Bruce
b. 19 Dec 1803
11
Frances Elizabeth Bruce
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.11.1]
b. 6 Sep 1830 d. 27 Sep 1915
Boardman F Stafford
b. 23 Apr 1827 d. 21 Oct 1886
12
Christopher Boardman Stafford
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.11.1.1]
b. Oct 1856 d. 1925 [
=>
]
12
Dwight Bliss Stafford
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.11.1.2]
b. 11 Jan 1860 d. 1936
12
Palmer A Stafford
[1.2.3.1.1.1.4.4.5.11.1.3]
b. 1 Jun 1869
9
Tamar Daggett
[1.2.3.1.1.1.4.4.6]
b. 24 Mar 1767 d. 23 Oct 1820
Eliphalet Holman
b. Abt 1761 d. 30 May 1838
10
Catharine Holman
[1.2.3.1.1.1.4.4.6.1]
b. 3 Dec 1789 d. 11 Aug 1864
John Cummings
b. 2 May 1786 d. 30 Oct 1832
11
Lucy Daggett Cummings
[1.2.3.1.1.1.4.4.6.1.1]
b. 18 Feb 1808 d. 9 Apr 1818
11
Tamar Holman Cummings
[1.2.3.1.1.1.4.4.6.1.2]
b. 19 Sep 1810 d. 5 Nov 1830
11
Eliphalet H Cummings
[1.2.3.1.1.1.4.4.6.1.3]
b. 2 Dec 1813 d. 15 Nov 1875
Harriet Aldrich
b. 12 Jun 1822 d. 15 Dec 1852
12
Cordelia Ann Cummings
[1.2.3.1.1.1.4.4.6.1.3.1]
b. 15 Dec 1841 d. 15 Jan 1856
12
George Francis "Franklin" Cummings
[1.2.3.1.1.1.4.4.6.1.3.2]
b. 27 Sep 1842 d. 30 Mar 1891 [
=>
]
+
Sarah D Cummings
b. Abt 1820
11
Daniel Cummings
[1.2.3.1.1.1.4.4.6.1.4]
b. 15 May 1816 d. 15 Nov 1875
11
Preston Cummings
[1.2.3.1.1.1.4.4.6.1.5]
b. 10 Jun 1818 d. 14 Sep 1868
11
Lucy Cummings
[1.2.3.1.1.1.4.4.6.1.6]
b. 10 Oct 1819 d. 27 Sep 1821
11
Catharine Cummings
[1.2.3.1.1.1.4.4.6.1.7]
b. 1 Oct 1821 d. 27 Nov 1896
11
Diantha Cummings
[1.2.3.1.1.1.4.4.6.1.8]
b. 29 Mar 1823 d. 21 Sep 1860
11
John Cummings
[1.2.3.1.1.1.4.4.6.1.9]
b. 25 Dec 1824 d. 20 Jul 1898
11
Mary Cummings
[1.2.3.1.1.1.4.4.6.1.10]
b. 22 Jul 1827 d. 1904
11
Candace H Cummings
[1.2.3.1.1.1.4.4.6.1.11]
b. 1829
11
Lucy Tamar Cummings
[1.2.3.1.1.1.4.4.6.1.12]
b. 16 Oct 1831 d. 30 Sep 1833
7
Samuel Sibley
[1.2.3.1.1.1.5]
b. 16 May 1697 d. Dec 1730
Martha Dike
b. Abt 1700 d. 5 Oct 1775
8
Samuel Sibley
[1.2.3.1.1.1.5.1]
b. 1724 d. 31 Aug 1801
8
Nathaniel Sibley
[1.2.3.1.1.1.5.2]
b. Abt 1725 d. 24 May 1811
Ruth Bradish
b. 7 May 1722 d. 12 Aug 1810
9
Ruth Sibley
[1.2.3.1.1.1.5.2.1]
b. 9 Apr 1745 d. 30 Nov 1814
Benoni Benson
b. 11 Jul 1747 d. 1803
10
John Benson
[1.2.3.1.1.1.5.2.1.1]
b. 1789
9
Martha Sibley
[1.2.3.1.1.1.5.2.2]
b. 17 Apr 1747 d. 4 Mar 1775
9
Mary Sibley
[1.2.3.1.1.1.5.2.3]
b. 1 Sep 1749
9
Eunice Sibley
[1.2.3.1.1.1.5.2.4]
b. 27 Feb 1752 d. Mar 1775
9
Nathan Sibley
[1.2.3.1.1.1.5.2.5]
b. 22 Jun 1754 d. 22 Feb 1755
9
Stephen Sibley
[1.2.3.1.1.1.5.2.6]
b. 21 Sep 1756
9
Nathaniel Sibley
[1.2.3.1.1.1.5.2.7]
b. 20 Apr 1759 d. 25 Aug 1775
9
Jonas Sibley
[1.2.3.1.1.1.5.2.8]
b. 7 Mar 1762 d. 5 Feb 1834
8
Lucy Sibley
[1.2.3.1.1.1.5.3]
b. 16 Apr 1726 d. 13 Dec 1821
8
Jeremiah Sibley
[1.2.3.1.1.1.5.4]
b. 31 Dec 1728 d. Abt 1807
8
Benjamin Sibley
[1.2.3.1.1.1.5.5]
b. 27 Feb 1731 d. Aft 27 Jan 1794
7
William Sibley
[1.2.3.1.1.1.6]
c. 7 Sep 1700 d. 18 Sep 1763
Sarah
b. Abt 1703
8
William Sibley
[1.2.3.1.1.1.6.1]
b. 4 May 1727
8
Elijah Sibley
[1.2.3.1.1.1.6.2]
b. Abt 1728
8
Sarah Sibley
[1.2.3.1.1.1.6.3]
b. 23 Aug 1730 d. 13 Jun 1816
8
Daniel Sibley
[1.2.3.1.1.1.6.4]
b. 31 Jan 1732
8
David Sibley
[1.2.3.1.1.1.6.5]
b. 3 Oct 1736
7
Benjamin Sibley
[1.2.3.1.1.1.7]
b. 19 Sep 1703 d. 2 Nov 1780
Pricilla Rich
b. 28 Sep 1706 d. 1 Feb 1782
8
Priscilla Sibley
[1.2.3.1.1.1.7.1]
b. 5 Aug 1725 d. 6 Feb 1737
8
Benjamin Sibley, Jr
[1.2.3.1.1.1.7.2]
b. 17 Aug 1727 d. 12 Nov 1789
8
Zuruiah Sibley
[1.2.3.1.1.1.7.3]
b. 31 Aug 1729 d. Aft 1770
8
Susanna Sibley
[1.2.3.1.1.1.7.4]
b. 31 Aug 1733 d. 24 Apr 1810
8
Ezra Sibley
[1.2.3.1.1.1.7.5]
b. 4 Aug 1738 d. 11 Oct 1762
8
Aaron Sibley
[1.2.3.1.1.1.7.6]
b. 2 Jul 1740 d. 1776
8
Moses Sibley
[1.2.3.1.1.1.7.7]
b. 9 May 1743 d. 16 Sep 1760
8
Joseph Sibley
[1.2.3.1.1.1.7.8]
b. 19 Aug 1745
8
Samuel Sibley
[1.2.3.1.1.1.7.9]
b. 14 Jun 1747 d. 1841
8
Jonathan Sibley
[1.2.3.1.1.1.7.10]
b. 4 Mar 1750 d. 31 Jul 1828
5
Elizabeth Black
[1.2.3.1.2]
b. Abt 1632
Sir Humphrey Gilbert
b. 1616 d. Bef 30 Mar 1658
6
Martha Gilbert
[1.2.3.1.2.1]
b. Abt 1651 d. Bef 4 Feb 1692
6
Abigail Gilbert
[1.2.3.1.2.2]
b. Abt 1654 d. 1735
6
Esther Gilbert
[1.2.3.1.2.3]
b. 1654
6
John Gilbert
[1.2.3.1.2.4]
b. 1656 d. 17 Mar 1722
Elizabeth Kilham
b. 1657 d. 17 Mar 1722
7
Mary Gilbert
[1.2.3.1.2.4.1]
b. Abt 1681 d. 1681
7
Elizabeth Gilbert
[1.2.3.1.2.4.2]
b. Abt 1683
7
Daniel Gilbert
[1.2.3.1.2.4.3]
b. Abt 1685 d. 2 Nov 1723
Elisabeth Porter
b. Abt 1689 d. Jan 1789
8
Lydia Gilbert
[1.2.3.1.2.4.3.1]
b. 9 Dec 1711 d. Abt 1757
8
Mary Gilbert
[1.2.3.1.2.4.3.2]
b. 17 Sep 1721 d. 1760
8
Elizabeth Gilbert
[1.2.3.1.2.4.3.3]
c. 13 Nov 1713 d. 21 Aug 1751
Joseph Noyes
b. 14 Jul 1710 d. 1754
9
Elizabeth Noyes
[1.2.3.1.2.4.3.3.1]
b. 18 Dec 1735 d. 9 Jul 1829
Thomas Phillips
b. 7 Jun 1747 d. 9 Jul 1829
10
Rhoda Phillips
[1.2.3.1.2.4.3.3.1.1]
b. Abt 1770 d. 23 Nov 1825
Enoch King
b. 22 Jan 1770 d. 8 Oct 1853
11
Betsy King
[1.2.3.1.2.4.3.3.1.1.1]
b. 1789 d. 20 Mar 1863
11
Lydia King
[1.2.3.1.2.4.3.3.1.1.2]
b. Abt 1789 d. 16 May 1835
11
Lucy King
[1.2.3.1.2.4.3.3.1.1.3]
b. Abt 1789 d. 1790
11
Electa King
[1.2.3.1.2.4.3.3.1.1.4]
b. Abt 1791 d. Aft 1870
11
Otis King
[1.2.3.1.2.4.3.3.1.1.5]
b. 15 Mar 1793 d. 20 Mar 1863
11
Rachael King
[1.2.3.1.2.4.3.3.1.1.6]
b. Abt 1799 d. 1801
11
Polly Mary King
[1.2.3.1.2.4.3.3.1.1.7]
b. 18 Dec 1799 d. 28 Oct 1881
11
Moses King
[1.2.3.1.2.4.3.3.1.1.8]
b. 1803 d. 20 Mar 1863
11
Dorcas King
[1.2.3.1.2.4.3.3.1.1.9]
b. 3 May 1804 d. 6 Oct 1876
11
Thomas Jefferson King
[1.2.3.1.2.4.3.3.1.1.10]
b. 27 May 1806 d. 23 Sep 1876
Rebecca Englesby Olin
b. 30 Apr 1805 d. 12 Nov 1876
12
George Elisha King
[1.2.3.1.2.4.3.3.1.1.10.1]
b. 23 Oct 1828 d. 28 Oct 1855 [
=>
]
12
William Jefferson King
[1.2.3.1.2.4.3.3.1.1.10.2]
b. 13 Jul 1833 d. 26 Jun 1860
12
Jonathan Alma King
[1.2.3.1.2.4.3.3.1.1.10.3]
b. 2 Feb 1835 d. Dec 1849
12
Amy Jane King
[1.2.3.1.2.4.3.3.1.1.10.4]
b. 2 Oct 1836 d. 8 Nov 1913 [
=>
]
12
Rhoda Eleanor King
[1.2.3.1.2.4.3.3.1.1.10.5]
b. 3 Oct 1839 d. 5 Jul 1840
12
Enoch Elmer King
[1.2.3.1.2.4.3.3.1.1.10.6]
b. 3 Oct 1839 d. 20 Feb 1850
12
Thomas Franklin King
[1.2.3.1.2.4.3.3.1.1.10.7]
b. 1 May 1842 d. 8 Jan 1913
12
Rebecca Angelina King
[1.2.3.1.2.4.3.3.1.1.10.8]
b. 29 Jun 1845 d. 1 Dec 1908
11
Enoch Edwin King
[1.2.3.1.2.4.3.3.1.1.11]
b. 1808 d. 23 Sep 1886
11
John Russell King
[1.2.3.1.2.4.3.3.1.1.12]
b. 16 Oct 1810 d. 28 Feb 1877
11
Rhoda King
[1.2.3.1.2.4.3.3.1.1.13]
b. 1811
10
Mary Phillips
[1.2.3.1.2.4.3.3.1.2]
b. 1 Oct 1774 d. 20 Apr 1844
10
Rachael Phillips
[1.2.3.1.2.4.3.3.1.3]
b. 1777 d. 9 Mar 1864
10
Russel Phillips
[1.2.3.1.2.4.3.3.1.4]
b. 31 Aug 1785 d. 15 Apr 1856
10
Caleb Phillips
[1.2.3.1.2.4.3.3.1.5]
b. Abt 1787
10
Moses Phillips
[1.2.3.1.2.4.3.3.1.6]
b. Abt 1789
10
Betsey Phillips
[1.2.3.1.2.4.3.3.1.7]
b. 1789 d. 1813
10
Dorcas Phillips
[1.2.3.1.2.4.3.3.1.8]
b. Abt 1789
9
Mary Noyes
[1.2.3.1.2.4.3.3.2]
b. 28 Dec 1737
9
Daniel Noyes
[1.2.3.1.2.4.3.3.3]
b. 10 Jun 1740 d. Abt 1824
9
Moses Noyes
[1.2.3.1.2.4.3.3.4]
b. 11 May 1743
8
Mercy Gilbert
[1.2.3.1.2.4.3.4]
c. 1 Apr 1716
8
Daniel Gilbert
[1.2.3.1.2.4.3.5]
c. 13 Apr 1718
8
Hannah Gilbert
[1.2.3.1.2.4.3.6]
c. 23 Dec 1722
7
Martha Gilbert
[1.2.3.1.2.4.4]
b. Abt 1688
7
Benjamin Gilbert
[1.2.3.1.2.4.5]
b. 1 Feb 1691 d. 24 Jun 1760
7
Joseph Gilbert
[1.2.3.1.2.4.6]
b. 1 Feb 1691 d. Mar 1763
7
Noah Gilbert
[1.2.3.1.2.4.7]
b. 21 Nov 1703 d. 22 Nov 1768
5
Lydia Black
[1.2.3.1.3]
b. 25 Dec 1636
5
Lydia Black
[1.2.3.1.4]
b. 3 Jun 1638 d. Bef 1748
5
John Black, Jr
[1.2.3.1.5]
b. 1642 d. 18 Aug 1700
4
Patrick Black
[1.2.3.2]
b. 28 Sep 1692
2
Gilbert Skene
[1.3]
b. Abt 1538 d. 1604
2
William Skene
[1.4]
b. Abt 1539 d. 29 Aug 1635
2
Patrick Skene
[1.5]
b. Abt 1540 d. 29 Aug 1635
2
Alexander Skene
[1.6]
b. Abt 1541 d. 1601