Home Page
|
What's New
|
Photos
|
Histories
|
Headstones
|
Reports
|
Surnames
Search
First Name:
Last Name:
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Suomalainen
Svenska
Alexander de Skeen
1498 - 1573 (75 years)
Submit Photo / Document
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Submit Photo / Doc
Worksheet
Family
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Alexander de Skeen
[1]
b. 1498 d. 1573
Elizabeth Black
b. Abt 1495 d. 1573
2
Alexander Skene
[1.1]
b. 1517 d. 1604
Elizabeth Forbes
b. 1517
3
James Skeen
[1.1.1]
b. Abt 1536 d. 1605
3
Agnes Skeen
[1.1.2]
b. Abt 1537 d. 1693
John Black
b. Abt 1540 d. 1591
4
Alexander Black
[1.1.2.1]
b. Abt 1559
4
Agnes Black
[1.1.2.2]
b. Abt 1564
4
John Black
[1.1.2.3]
b. Abt 1565
Elizabeth Locart
b. 1570 d. 1641
5
John Black
[1.1.2.3.1]
b. Abt 1613 d. 1 Mar 1675
Susanna Freeman
b. Abt 1610 d. Aft 1645
6
Persis Black
[1.1.2.3.1.1]
b. Abt 1627 d. 20 Jul 1677
William Follett
b. Abt 1625
7
Susanna Follett
[1.1.2.3.1.1.1]
b. 1 Jun 1662
Joseph Sibley
b. 1655 d. 25 Apr 1711
8
Joseph Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.1]
b. 9 Nov 1685 d. 1754
Elizabeth Boutwell
b. 2 Mar 1683 d. Bef 1734
9
Joseph Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.1.1]
b. 6 Mar 1709 d. 22 Aug 1777
9
John Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.1.2]
b. 2 Aug 1711 d. 27 Nov 1778
9
James Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.1.3]
b. 7 May 1714
9
Elizabeth Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.1.4]
b. Abt 1716
9
Jonathan Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.1.5]
b. 11 Sep 1718 d. 30 Mar 1787
9
Hannah Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.1.6]
b. 27 Jun 1721
9
Susanna Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.1.7]
b. 24 Aug 1723
9
Mary Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.1.8]
b. 23 Sep 1725
8
John Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2]
b. 18 Sep 1687 d. 13 May 1741
Zerviah Gould
b. 20 Apr 1694 d. Bef 1741
9
Ebenezer Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.1]
b. 28 Feb 1717 d. 4 Mar 1790
Abigail Cummings
b. 3 May 1716 d. 27 Sep 1783
10
Stephen Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.1.1]
b. 12 Jul 1741 d. 25 Aug 1828
Thankful Taft
b. 25 May 1745 d. 26 Oct 1837
11
Joel Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.1.1.1]
b. 25 Apr 1766 d. 10 Apr 1839
Lois Louise Woods
b. 24 Jun 1767 d. 21 Nov 1832
12
Amory Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.1.1.1.1]
b. 20 Jun 1792 d. 22 Jun 1849 [
=>
]
12
Josiah Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.1.1.1.2]
b. 1 Apr 1808 d. 7 Dec 1888 [
=>
]
11
Lydia Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.1.1.2]
b. 2 Apr 1769 d. 27 Nov 1822
Henry Staples Benson
b. 8 Aug 1770 d. 29 Jul 1821
12
Abigail Benson
[1.1.2.3.1.1.1.2.1.1.2.1]
b. 31 Mar 1795 d. 10 Nov 1821 [
=>
]
12
Harriet Benson
[1.1.2.3.1.1.1.2.1.1.2.2]
b. 14 Sep 1796 d. 22 Aug 1852
12
Mellen Benson
[1.1.2.3.1.1.1.2.1.1.2.3]
b. 14 Jan 1798 [
=>
]
12
Hannah Adaline Benson
[1.1.2.3.1.1.1.2.1.1.2.4]
b. 12 Aug 1802 d. 19 Jun 1822
12
Rufus Benson
[1.1.2.3.1.1.1.2.1.1.2.5]
b. 24 Jan 1804 d. 23 Aug 1805
12
Chloe Ann Benson
[1.1.2.3.1.1.1.2.1.1.2.6]
b. 23 Aug 1806
12
Susan Augusta Benson
[1.1.2.3.1.1.1.2.1.1.2.7]
b. 9 Oct 1809 d. 25 Jul 1831 [
=>
]
12
Rufus Aldrich Benson
[1.1.2.3.1.1.1.2.1.1.2.8]
b. 9 Oct 1809
12
Stephen Sibley Benson
[1.1.2.3.1.1.1.2.1.1.2.9]
b. 9 Jan 1810 d. 20 Nov 1869 [
=>
]
10
Ebenezer Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.1.2]
b. 9 Oct 1745
Mary Chase
b. 15 Mar 1741 d. 1784
11
Sarah Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.1.2.1]
b. 19 Dec 1772
11
Lucy Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.1.2.2]
b. 2 Mar 1775
+
Forbes Bond
b. Abt 1773
11
Eunice Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.1.2.3]
b. 1 Mar 1777
11
Elias Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.1.2.4]
b. 8 Aug 1779 d. 1856
Ruth Chase
b. 31 Jan 1780 d. Abt 1858
12
Alonzo Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.1.2.4.1]
b. 14 Jul 1810 d. 16 Mar 1896 [
=>
]
11
Ebenezer Sibley, Jr
[1.1.2.3.1.1.1.2.1.2.5]
b. 18 Jan 1782 d. 15 Mar 1827
Polly B Whipple
b. 16 Jun 1791
12
Lorinda Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.1.2.5.1]
b. 6 Jul 1810
12
Maria Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.1.2.5.2]
b. 23 Jul 1812 [
=>
]
12
Polly Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.1.2.5.3]
b. 11 Sep 1814
12
Mary Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.1.2.5.4]
b. 8 Mar 1817 d. 17 Jun 1903 [
=>
]
12
Loren Elba Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.1.2.5.5]
b. 3 May 1821
11
Zadock Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.1.2.6]
b. 12 Oct 1785
11
Mary Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.1.2.7]
b. 1 Feb 1789 d. 24 Apr 1844
+
Amos Peirce
b. Abt 1786 d. 22 Dec 1848
10
Abigail Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.1.3]
b. 22 Jan 1747
10
Peter Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.1.4]
b. 16 Sep 1749
10
Mary Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.1.5]
b. 20 Jan 1751
9
Stephen Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.2]
b. 1 Oct 1720
Mrs Sibley
b. Abt 1725
10
Elias Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.2.1]
b. Abt 1745
9
Bethiah Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.3]
b. 2 Oct 1724 d. 1 Jul 1756
Samuel Trask
b. 17 Dec 1721 d. 7 Mar 1790
10
John Trask
[1.1.2.3.1.1.1.2.3.1]
b. 29 Sep 1744
10
Hannah Trask
[1.1.2.3.1.1.1.2.3.2]
b. 10 Nov 1746
10
Sarah Trask
[1.1.2.3.1.1.1.2.3.3]
b. 10 Sep 1753 d. 22 Aug 1830
Major Simon Tenney
b. 13 Sep 1746 d. 14 Aug 1838
11
Major Daniel Tenney
[1.1.2.3.1.1.1.2.3.3.1]
b. 23 Nov 1773
Betsey Waters
b. 12 Jul 1776 d. 16 Aug 1851
12
Sarah Tenney
[1.1.2.3.1.1.1.2.3.3.1.1]
b. 6 Oct 1797 d. 13 Apr 1880 [
=>
]
12
Sally Tenney
[1.1.2.3.1.1.1.2.3.3.1.2]
b. 6 Oct 1797
12
Simon Tenney
[1.1.2.3.1.1.1.2.3.3.1.3]
b. 3 Dec 1799 d. 11 Jun 1856 [
=>
]
12
John Waters Tenney
[1.1.2.3.1.1.1.2.3.3.1.4]
b. 25 Jul 1802 d. 29 Apr 1849 [
=>
]
12
Linus Tenney
[1.1.2.3.1.1.1.2.3.3.1.5]
b. 5 Dec 1804 [
=>
]
12
Nancy Tenney
[1.1.2.3.1.1.1.2.3.3.1.6]
b. 21 Jan 1808 d. 29 May 1822
12
Danial Austin Tenney
[1.1.2.3.1.1.1.2.3.3.1.7]
b. 29 Aug 1811 d. 7 Feb 1871 [
=>
]
12
Benjamin Franklin Tenney
[1.1.2.3.1.1.1.2.3.3.1.8]
b. 28 Oct 1813 d. 26 Oct 1900 [
=>
]
10
Samuel Trask, Jr
[1.1.2.3.1.1.1.2.3.4]
b. 26 Aug 1749
Ruth Tenney
b. 16 Mar 1753 d. 27 Apr 1789
11
Samuel Trask, III
[1.1.2.3.1.1.1.2.3.4.1]
b. 10 Dec 1773
11
Simon Trask
[1.1.2.3.1.1.1.2.3.4.2]
b. 13 Jan 1775
11
Hannah Trask
[1.1.2.3.1.1.1.2.3.4.3]
b. 4 Feb 1777
11
Stephen Trask
[1.1.2.3.1.1.1.2.3.4.4]
b. 18 Feb 1779
11
Salley Trask
[1.1.2.3.1.1.1.2.3.4.5]
b. 17 Jan 1784 d. 5 Feb 1819
Elijah Holman
12
Jonathan Holman
[1.1.2.3.1.1.1.2.3.4.5.1]
b. 21 Jun 1813 d. 24 Oct 1816
12
Sarah Trask Holman
[1.1.2.3.1.1.1.2.3.4.5.2]
b. 16 May 1816 d. 8 May 1847 [
=>
]
12
Son Holman
[1.1.2.3.1.1.1.2.3.4.5.3]
b. Abt 1819 d. 23 Feb 1826
Allice Perry
b. Abt 1759
11
Talmon Trask
[1.1.2.3.1.1.1.2.3.4.6]
c. 6 Oct 1799
11
Danforth Trask
[1.1.2.3.1.1.1.2.3.4.7]
c. 27 Nov 1801
11
Dexter Trask
[1.1.2.3.1.1.1.2.3.4.8]
c. 11 Aug 1807
11
Edwin Trask
[1.1.2.3.1.1.1.2.3.4.9]
c. 29 Sep 1809
11
Angelina Trask
[1.1.2.3.1.1.1.2.3.4.10]
c. 26 Oct 1811
10
Anne Trask
[1.1.2.3.1.1.1.2.3.5]
b. 9 Oct 1757
9
Timothy Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4]
b. 2 Nov 1727 d. 6 Dec 1818
Ann Waite
b. 14 Oct 1733 d. 12 Mar 1791
10
John Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.1]
b. 19 May 1757 d. 8 Apr 1837
Betsey Hopkins
b. Abt 1754 d. 1790
11
George Champlin Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.1.1]
b. 1 Apr 1782 d. 31 Jan 1863
+
Mary Smith Easton
b. 24 Jan 1800 d. 20 Jun 1878
10
Timothy Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.2]
b. 19 Jun 1754 d. 26 Aug 1829
Mary
b. Abt 1756
11
Timothy Willard Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.2.1]
b. 11 Sep 1779 d. 11 Mar 1820
Elizabeth Comins
d. 2 Mar 1820
12
William C Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.2.1.1]
b. 20 Jun 1812
12
Sarah Elizabeth Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.2.1.2]
b. 2 Jan 1814
12
Mary Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.2.1.3]
b. 26 Sep 1815
12
Amanda M Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.2.1.4]
b. 25 Jun 1817
12
Nancy W Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.2.1.5]
b. 10 Jul 1819 [
=>
]
12
Almira S Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.2.1.6]
11
Mary Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.2.2]
b. 5 Dec 1780
+
Amariah Scarboro
11
Anne Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.2.3]
b. 15 Jan 1782
11
Cyrus Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.2.4]
b. 6 Jan 1784
Eliza Ann Humphries
b. 9 Sep 1809 d. 4 Oct 1884
12
Artemas Origin Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.2.4.1]
b. 9 Mar 1829 [
=>
]
12
Salome Jane Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.2.4.2]
b. 19 Dec 1829 d. 12 Apr 1835
12
Artemesia Ann Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.2.4.3]
b. 31 Jul 1830 d. 1 Sep 1903 [
=>
]
12
Willard Franklin Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.2.4.4]
b. 18 Apr 1835
12
Cyrus Blue Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.2.4.5]
b. 18 Apr 1837
12
Helena Jane Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.2.4.6]
b. 27 May 1839
12
Henrietta Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.2.4.7]
b. 1842 d. 6 Feb 1892
12
Walter Howard Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.2.4.8]
12
Augustus Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.2.4.9]
11
Artemas Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.2.5]
b. 21 Apr 1786
11
Salome Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.2.6]
b. 13 Apr 1788 d. Aft 1880
Elijah Jewett
b. 8 Feb 1782 d. 1879
12
John F Jewett
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.2.6.1]
b. 1817
12
Origin Sibley Jewett
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.2.6.2]
b. 20 Apr 1820 d. 19 Sep 1863 [
=>
]
12
Mary Elizabeth Jewett
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.2.6.3]
b. Abt 1821 d. 1901 [
=>
]
11
Benijamin Franklin Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.2.7]
b. 19 Jul 1790
11
Origen Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.2.8]
b. 1792 d. 1870
Elizabeth Barlow
b. 8 May 1815 d. 2 Jul 1875
12
Josephine Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.1]
b. 2 Jul 1835 d. 3 Mar 1873 [
=>
]
12
Salome Elizabeth Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.2]
b. 19 Aug 1837 d. 1 Nov 1893 [
=>
]
12
Origen Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.3]
b. 6 Feb 1840 [
=>
]
12
Laura Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.4]
b. 1842 [
=>
]
12
Franklin Edward Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.5]
b. 1844 [
=>
]
12
Helen Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.6]
b. 15 Dec 1846 d. 1940 [
=>
]
12
Charles Sweet Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.7]
b. 25 Jan 1849 [
=>
]
12
Eugene Wilson Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.8]
b. 16 Sep 1851 d. 4 Mar 1911 [
=>
]
12
Guy Clarence Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.9]
b. 1855 [
=>
]
12
Julia Eve Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.2.8.10]
b. 16 Jan 1856 [
=>
]
10
Joshua Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.3]
b. 16 Nov 1755 d. 29 Sep 1774
10
Stephen Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.4]
b. 19 May 1757 d. 2 Jun 1759
10
Stephen Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.5]
b. 10 Nov 1759 d. 21 Apr 1829
10
Ebenezer Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.6]
b. 7 Apr 1761 d. 10 Sep 1839
Lydia Beach
b. 15 May 1766 d. 6 Mar 1834
11
John Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.6.1]
b. 3 Jul 1791
Nancy Kellog
b. 12 Mar 1809 d. 13 Jun 1885
12
Huldah Ann Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.6.1.1]
b. 13 Dec 1839 d. 30 Aug 1874 [
=>
]
12
Ebenezer Kellogg Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.6.1.2]
b. 21 Sep 1841 d. 29 Sep 1895
12
George Whitney Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.6.1.3]
b. 17 Jan 1843 d. 7 Jul 1911 [
=>
]
12
John Nelson Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.6.1.4]
b. 10 Nov 1844 d. 4 Jan 1880
12
Benjamin Franklin Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.6.1.5]
b. 5 Aug 1846 d. 1907 [
=>
]
12
Hiram Beach Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.6.1.6]
b. 4 Mar 1849 d. 20 Sep 1876
11
Timothy Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.6.2]
b. 4 Feb 1803 d. 24 Sep 1880
10
Anna Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.7]
b. 15 Dec 1762 d. 17 Sep 1792
Samuel Hoyt
b. 24 Jan 1739 d. 22 Nov 1821
11
Lydia Hoyt
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.7.1]
b. 9 Apr 1779 d. Aft 1850
Jonathan Bean
b. 26 Feb 1776 d. 9 Nov 1844
12
Sopia Bean
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.7.1.1]
b. 16 Jun 1799
12
Fanny Bean
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.7.1.2]
b. 20 Jan 1801
12
Otis Bean
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.7.1.3]
b. 26 Dec 1802
12
Asa Bean
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.7.1.4]
b. 13 Mar 1805 d. 18 Apr 1856 [
=>
]
12
Synthia Bean
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.7.1.5]
b. 26 Dec 1807 d. 15 Oct 1816
12
Eliza Bean
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.7.1.6]
b. 26 Dec 1807 d. 15 Oct 1816
12
Rueben C Bean
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.7.1.7]
b. 2 Apr 1809
12
Ann Bean
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.7.1.8]
b. 22 May 1811
12
Mary Bean
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.7.1.9]
b. 2 May 1813
12
Martha Bean
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.7.1.10]
b. 15 Dec 1815 d. 6 Jan 1818
11
Anna Hoyt
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.7.2]
b. 26 Sep 1781 d. 16 Sep 1865
Paulus Tenney
b. 24 Sep 1781 d. 29 Sep 1841
12
Maria Tenney
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.7.2.1]
b. 4 Jun 1805 d. 1 May 1812
12
Franklin Tenney
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.7.2.2]
b. 5 Nov 1806 d. 15 Nov 1878
12
Nancy S Tenney
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.7.2.3]
b. 28 Oct 1808 d. 1885 [
=>
]
12
Sylvainus Tenny
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.7.2.4]
b. 6 Oct 1810 d. 12 Oct 1888 [
=>
]
11
William Hoyt
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.7.3]
b. 24 Jul 1783 d. 19 Feb 1813
Polly French
b. Abt 1785
12
Freeman Hoyt
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.7.3.1]
b. 1805
12
Mary French Hoyt
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.7.3.2]
b. Abt 1809
12
Sewell Hoyt
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.7.3.3]
b. Abt 1811
12
William Hoyt
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.7.3.4]
b. Abt 1813
12
French Hoyt
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.7.3.5]
b. Abt 1815
11
Sarah Hoyt
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.7.4]
b. 13 Feb 1786 d. 14 Nov 1862
John Hoyt
b. 2 Dec 1787
12
Sophronia Hoyt
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.7.4.1]
b. 21 Dec 1810 d. 12 Feb 1889 [
=>
]
12
William Hoyt
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.7.4.2]
b. 12 Oct 1813
12
Samuel True Hoyt
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.7.4.3]
b. Abt 1814
12
True Worthy Hoyt
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.7.4.4]
b. 31 Aug 1815 d. 1900 [
=>
]
12
Albert Lewis Hoyt
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.7.4.5]
b. 23 Dec 1822 d. 10 Aug 1843
10
Asa Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.8]
b. 29 Mar 1764 d. 25 Feb 1829
Irene Carpenter
b. 28 Jan 1766 d. 5 Oct 1846
11
Derick Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.8.1]
b. 22 May 1788 d. Abt 1846
Rachael Roberts
b. 1800 d. Aft 1860
12
Caroline Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.8.1.1]
b. 1833 d. Aft 1860 [
=>
]
11
Sophia Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.8.2]
b. 5 Oct 1790 d. 4 Feb 1841
Oren Hall
b. 1789 d. Dec 1820
12
Sophia Edna Hall
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.8.2.1]
b. 1 Apr 1809 d. 1870 [
=>
]
12
Edwin Oscar Hall
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.8.2.2]
b. 21 Oct 1810 d. 19 Sep 1883 [
=>
]
12
Asa Sibley Hall
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.8.2.3]
b. 23 Apr 1818
Joseph Willard Seymour
b. 29 Mar 1781 d. 25 Jan 1867
12
Oren T Seymour
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.8.2.4]
b. 1824
12
Mary E. Seymour
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.8.2.5]
b. Abt 1825 d. Aft 1850
12
Theodore S. Seymour
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.8.2.6]
b. 1 Jul 1828 d. 1902
11
Lucy Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.8.3]
b. 21 Jul 1792 d. 18 Jul 1795
11
Levi Waite Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.8.4]
b. 4 Mar 1801 d. 13 Aug 1844
Nancy Ann Remington
b. 18 Sep 1801 d. 9 Jan 1870
12
Augustus Furburt Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.8.4.1]
b. 15 Jul 1827 [
=>
]
12
Amanda Maria Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.8.4.2]
b. 25 Oct 1829 d. 31 Mar 1861 [
=>
]
12
William Wisner Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.8.4.3]
b. 4 Feb 1831 d. 30 Jun 1870
12
Harriet Remington Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.8.4.4]
b. 12 Jul 1833 d. Aug 1844
12
George Ainsworth Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.8.4.5]
b. 13 Jun 1834 d. 29 Dec 1856
12
Levi Edwin Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.8.4.6]
b. 8 Sep 1839 d. 29 Oct 1900 [
=>
]
11
Mary Ann Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.8.5]
b. 18 Dec 1804 d. 18 Oct 1870
Edwin Scrantom
b. 9 May 1803 d. 3 Oct 1880
12
Stella Benton Scrantom
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.8.5.1]
b. 12 Jan 1827
12
Adrian George Scrantom
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.8.5.2]
b. 26 Oct 1828 d. 1880
12
Cora Irene Scrantom
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.8.5.3]
b. 28 Jun 1830 d. 31 Dec 1858 [
=>
]
12
Edwina Jane Scrantom
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.8.5.4]
b. 24 Sep 1832 d. Abt 1839
12
Hamlet Edwin Scrantom
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.8.5.5]
b. Abt 1833 d. Abt 1833
12
Beulah Mary Scrantom
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.8.5.6]
b. 15 Jan 1835 d. 1 Jan 1900 [
=>
]
12
Edwin Levi Scrantom
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.8.5.7]
b. Abt 1837 d. Abt 1837
12
Clifford Sibley Scrantom
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.8.5.8]
b. Abt 1841 d. Abt 1844
12
Melford Clark Scrantom
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.8.5.9]
b. 4 Nov 1844 d. Abt 1845
12
Bertha Sibley Scranton
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.8.5.10]
b. 29 Nov 1848
11
George Ainsworth Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.8.6]
b. 9 Apr 1809 d. 1 Jun 1836
11
Daughter Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.8.7]
c. 1 Oct 1809 d. 1809
10
Jonathan Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.9]
b. 8 May 1766 d. 20 Feb 1823
Mary Davis
b. 24 Feb 1768 d. 23 Jun 1840
11
Davis Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.9.1]
b. 29 Nov 1788 d. 21 Nov 1828
Cynta Fisher
b. Abt 1797 d. 6 Jul 1874
12
Nelson Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.9.1.1]
b. 4 Mar 1820 d. 10 Mar 1850
12
Franklin Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.9.1.2]
b. 1 Oct 1821 d. 1878 [
=>
]
12
Laura Messenger Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.9.1.3]
b. 6 Dec 1822 d. 13 Jan 1861
12
Mary Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.9.1.4]
b. 15 Apr 1825 d. 21 Aug 1826
12
Martha Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.9.1.5]
b. 18 Jun 1826 d. Sep 1826
12
Mary Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.9.1.6]
b. 7 Aug 1827 d. 16 Oct 1840
12
Caroline F Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.9.1.7]
b. 14 Dec 1828 d. 7 Apr 1853
11
Mary Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.9.2]
b. 13 Apr 1792 d. 9 Nov 1844
Augustine White
b. 19 Jan 1777
12
Mary Ann White
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.9.2.1]
b. 19 Apr 1812 d. 12 May 1823
12
Eliza Malvina White
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.9.2.2]
b. 30 Nov 1814 d. 7 Apr 1858
12
Cynthia Sibley White
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.9.2.3]
b. 8 May 1818
12
Augusta Holven White
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.9.2.4]
b. 28 Jan 1821
12
Lucy Violy White
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.9.2.5]
b. 20 Oct 1824 d. Jul 1845
12
John S White
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.9.2.6]
b. 2 Jul 1827
12
Davis J White
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.9.2.7]
b. 27 Jan 1833
11
Jonathan W Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.9.3]
b. 13 Aug 1800 d. 26 Sep 1829
Brooksey Case
b. 30 Sep 1804 d. 15 Mar 1829
12
Albert C Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.9.3.1]
b. 3 Jun 1828 d. Feb 1852
10
Benjamin Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.10]
b. 29 Apr 1768 d. 2 Oct 1829
Zilpah Davis
b. 13 Apr 1771 d. 16 May 1824
11
Samuel Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.10.1]
b. 30 Nov 1792 d. 4 Mar 1858
Lucinda Holbrock
b. 19 Mar 1806 d. 2 Mar 1830
12
Giles H Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.10.1.1]
b. 26 May 1825 d. 10 Jun 1825
12
Morella Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.10.1.2]
b. 19 Jun 1827 d. 31 Jul 1849
12
Lucinda Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.10.1.3]
b. 12 Jul 1829 d. 4 Sep 1854
Almira Dixon
b. 3 Apr 1807
12
Elizabeth H Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.10.1.4]
b. 20 Nov 1833
12
Mary Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.10.1.5]
b. 16 Jan 1838 d. 17 Aug 1839
12
Helen Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.10.1.6]
b. 23 Sep 1842 d. 3 Feb 1844
12
George H Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.10.1.7]
b. 25 Aug 1845
11
Patty Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.10.2]
b. 6 Feb 1799 d. 12 Jul 1805
11
Nancy Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.10.3]
b. 7 Feb 1806 d. 14 Feb 1806
11
Hiram Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.10.4]
b. 6 Feb 1807 d. 12 Jul 1888
Elizabeth Maria Tinker
b. 11 Aug 1815 d. 11 Jul 1903
12
Zilpha Louisa Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.10.4.1]
b. 7 Dec 1833 d. 16 Jun 1868 [
=>
]
12
Giles Benjamin Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.10.4.2]
b. 8 Apr 1841 d. 14 Mar 1843
12
Hiram Watson Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.10.4.3]
b. 2 Mar 1845 d. 28 Jun 1932 [
=>
]
12
Emily Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.10.4.4]
b. 10 May 1855 d. 8 Feb 1945 [
=>
]
10
Soloman Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.11]
b. 17 Nov 1769
Sally Stockwell
b. 21 Jan 1774
11
Stephen Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.11.1]
b. 12 Dec 1792
11
Nancy Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.11.2]
b. 19 Jan 1797
+
Nathan Muzzy
b. 24 Dec 1792 d. 23 Jun 1858
11
Heister Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.11.3]
b. 19 Jun 1799
11
Lewis Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.11.4]
b. 8 Jul 1801
11
Stephen Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.11.5]
b. 26 Jul 1805
Charlotte Reed Peirce
b. 7 Jul 1811 d. 22 Aug 1882
12
John Reed Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.11.5.1]
b. 18 Apr 1838
12
George H Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.11.5.2]
b. 17 Aug 1841
12
Martha P Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.11.5.3]
b. 16 Nov 1843
12
Mary Charlotte Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.11.5.4]
b. 18 May 1847 [
=>
]
12
Clara Sophronia Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.11.5.5]
b. 8 Nov 1849 [
=>
]
11
Solomon Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.11.6]
b. 14 Jun 1808
11
John Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.11.7]
b. 20 Feb 1818 d. 17 Aug 1824
10
Polly Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.12]
b. 4 Dec 1771
Abner C Cummings
b. 9 Oct 1770 d. 1800
11
Nancy Cummings
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.12.1]
b. 5 Nov 1795
John Putnam
b. Abt 1792
12
Dulcina Putnam
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.12.1.1]
b. 12 Dec 1813 d. 20 Jul 1816
12
Harriet Putnam
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.12.1.2]
b. 20 Mar 1815 d. 20 Jul 1816
12
Jane Putnam
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.12.1.3]
b. 1 Nov 1816 [
=>
]
12
John Perry Putnam
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.12.1.4]
b. 27 Mar 1818
12
Ira Putnam
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.12.1.5]
b. 15 Nov 1819 d. 12 May 1821
12
Ephraim Laughton Putnam
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.12.1.6]
b. 30 Apr 1821 d. 3 Dec 1822
11
Clarissa Cummings
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.12.2]
b. 18 Apr 1796 d. 1838
Creenfield Pote Merrill
b. 26 Aug 1794 d. 27 Mar 1876
12
Edward Pote Merrill
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.12.2.1]
b. 22 Oct 1820 d. 1870
12
Elizabeth C Merrill
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.12.2.2]
b. 26 Feb 1822 d. 16 Dec 1839
12
Greenfield Merrill
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.12.2.3]
b. 14 Dec 1825
12
Samuel Merrill
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.12.2.4]
b. 28 Oct 1832 d. 1912
12
Creenfield Merrill
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.12.2.5]
b. 14 Dec 1834
12
Daniel Cummings Merrill
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.12.2.6]
b. 20 Mar 1837 d. 1925
10
Artamus Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.13]
b. 9 Jul 1773 d. 10 Aug 1777
10
Nahum Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.14]
b. 11 Sep 1775 d. 12 Sep 1796
10
Sally Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.15]
b. 6 Jun 1779 d. 21 Mar 1833
Amasa Cummings
b. 17 Jan 1778 d. 22 Mar 1836
11
Abner Cummings
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.15.1]
b. 1 Jan 1808
11
Sarah Ann Cummings
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.15.2]
b. 22 Oct 1812
11
Nahum Sibley Cummings
[1.1.2.3.1.1.1.2.4.15.3]
b. 7 Jan 1816
+
Hannah Amidon
b. Abt 1730 d. 5 Jun 1822
8
Jonathan Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.3]
b. 1 May 1690 d. Abt 1733
Mary Cutler
b. 19 Mar 1691 d. 1734
9
Martha Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.3.1]
b. 10 Jul 1731
8
Hannah Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.4]
c. 9 May 1695 d. 8 Feb 1731
Ebenezer Daggett
b. 22 Nov 1693 d. 8 Apr 1762
9
Ebenezer Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.1]
b. 13 Apr 1723 d. Bef 3 Aug 1761
9
Thomas Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.2]
b. 21 Apr 1725 d. 28 Nov 1758
Martha Stockwell
b. 25 Mar 1724
10
Captain John Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.1]
b. 15 Sep 1748 d. 8 Feb 1816
Mary Stevens
b. 1749
11
Thomas Dagget
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.1.1]
b. 5 Aug 1776
Ruth Record
c. 25 Jan 1777
12
Elisha Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.1.1.1]
b. Abt 1801 d. Abt 1881
12
Ruth Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.1.1.2]
b. Abt 1804 d. 1881
12
Thomas Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.1.1.3]
b. Abt 1806
11
John Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.1.2]
b. 14 Oct 1778 d. 6 Jan 1824
Sarah Record
b. 1780 d. 25 Oct 1821
12
Luther Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.1.2.1]
b. 19 Nov 1800
12
Betsey Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.1.2.2]
b. 25 Nov 1802 [
=>
]
12
Calvin Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.1.2.3]
b. 24 Jan 1806 d. 1 Jul 1832 [
=>
]
12
Sarah Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.1.2.4]
b. 27 Dec 1809 d. 30 Jun 1832
12
Lucy Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.1.2.5]
b. 15 Aug 1812
12
Anna Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.1.2.6]
b. 26 Nov 1814
12
John Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.1.2.7]
b. 16 Nov 1817
12
Silas Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.1.2.8]
b. 20 Jun 1821
11
Sarah Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.1.3]
b. 2 Apr 1780 d. 1873
Captain Samuel Bates
b. Abt 1776
12
Florentine Bates
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.1.3.1]
b. Abt 1802
12
Simeon Bates
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.1.3.2]
b. Abt 1804
12
Marilla Bates
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.1.3.3]
b. Abt 1806
12
Sarah Bates
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.1.3.4]
b. Abt 1808
11
Simeon Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.1.4]
b. Abt 1782
11
Simon Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.1.5]
b. 1786 d. 1807
11
Captain Aaron Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.1.6]
b. 4 Mar 1787 d. 1 Feb 1862
Almira Dearborn
b. 7 May 1789 d. 11 Mar 1830
12
Greenlief Dearborn Quincy Adams Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.1.6.1]
b. 10 Nov 1818 d. 23 Jul 1854
12
Converse Rollin Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.1.6.2]
b. 14 Mar 1820 [
=>
]
12
Simon Dearborn Alfred Pierce Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.1.6.3]
b. 19 Sep 1822 d. 11 Aug 1840
12
Molly Dearborn Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.1.6.4]
b. 13 Apr 1826 d. 23 Apr 1826
12
Almira Augusta Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.1.6.5]
b. 28 Sep 1827 d. 27 Mar 1865
Dorcas C Dearborn
b. 13 Jun 1796 d. 24 Mar 1869
12
Ebenezer Sanborn Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.1.6.6]
b. 30 Sep 1831
12
John Carroll Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.1.6.7]
b. 29 Jul 1833 d. 12 Dec 1902 [
=>
]
12
Mary Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.1.6.8]
b. 9 Jan 1835 d. 1 Oct 1861
12
Brigadier General Aaron Simon Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.1.6.9]
b. 14 Jan 1837 d. 14 May 1931 [
=>
]
11
Mary Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.1.7]
b. 5 Jul 1789
Luther Robbins
b. Abt 1785
12
Louisiana Robbins
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.1.7.1]
b. Abt 1811
12
Survetus Robbins
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.1.7.2]
b. Abt 1813
12
Mary Robbins
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.1.7.3]
b. Abt 1815
12
John Robbins
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.1.7.4]
b. Abt 1817
12
Clementine Robbins
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.1.7.5]
b. Abt 1819
+
Sarah Jones
b. 26 Oct 1749 d. Bef 1775
10
Mary Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.2]
b. 29 Mar 1750 d. Aft 25 Sep 1826
Seth Corbett Jones
b. 21 Mar 1748 d. 14 Apr 1827
11
Samuel Jones
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.2.1]
b. 5 Aug 1773 d. 24 Aug 1846
Matilda Davis
b. 13 Aug 1777 d. Aft 1820
12
Reuben Davis Jones
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.2.1.1]
b. 30 Jul 1798 d. 22 Feb 1866 [
=>
]
12
Seth Corbitt Jones
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.2.1.2]
b. 23 Sep 1800 d. 21 Jul 1867 [
=>
]
12
Sallie Jones
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.2.1.3]
b. 1802
12
Ezra Jones
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.2.1.4]
b. 1804 d. 1807
12
Ezra Jones
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.2.1.5]
b. 12 Jul 1807 d. 3 Aug 1879 [
=>
]
Lucinda Kingsley
b. 21 Jan 1798 d. 23 Dec 1882
12
Frederick Jones
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.2.1.6]
b. 22 Feb 1819 d. 8 Jul 1849
12
William Henry Jones
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.2.1.7]
b. 22 Oct 1820 d. 21 Aug 1909
12
Samuel Jones
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.2.1.8]
b. 13 Oct 1822 d. 1839
12
Nathaniel Vary Jones
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.2.1.9]
b. 13 Oct 1822 d. 15 Feb 1863 [
=>
]
12
Calvin Kingsley Jones
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.2.1.10]
b. 9 Jul 1824 d. 30 Oct 1915
Polly Baxter
b. 11 Oct 1797 d. 6 Jan 1851
12
Isabel Jones
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.2.1.11]
b. 16 Jan 1836 d. 6 Mar 1913 [
=>
]
12
Harriet Jones
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.2.1.12]
b. 2 Apr 1838 d. Aft 1855
11
Aaron Jones
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.2.2]
b. 23 Mar 1775
11
Sarah Jones
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.2.3]
b. 23 Sep 1777 d. 17 May 1838
Joel Pratt
b. Abt 1776 d. 18 May 1866
12
Reuben Pratt
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.2.3.1]
b. 13 Nov 1803 d. 31 May 1861 [
=>
]
12
Nelson Chapin Pratt
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.2.3.2]
b. 18 Jul 1805 d. 14 Mar 1864 [
=>
]
12
Seth Corbett Pratt
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.2.3.3]
b. 2 Sep 1807 d. 2 Jun 1880 [
=>
]
12
Lawson Pratt
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.2.3.4]
b. 13 Sep 1810 [
=>
]
12
Esther Pratt
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.2.3.5]
b. 12 Dec 1812 [
=>
]
12
Marilla May Pratt
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.2.3.6]
b. 3 Sep 1814 d. 4 Mar 1835
12
Joel Pratt
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.2.3.7]
b. 3 Sep 1817 d. 1822
12
Sarah Jane Pratt
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.2.3.8]
b. 30 Aug 1819 d. 12 May 1838
11
Mary Jones
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.2.4]
b. 9 Dec 1780 d. 30 Oct 1831
John Bigelow
b. 12 Aug 1787 d. 6 Sep 1808
12
Mary Dagget Bigelow
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.2.4.1]
b. 4 Apr 1807 d. 6 Mar 1873 [
=>
]
12
John Jones Bigelow
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.2.4.2]
b. 31 Jan 1809 d. 2 Jun 1848 [
=>
]
11
Lydia Jones
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.2.5]
b. 15 Oct 1783
11
Seth Corbett Jones, Jr
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.2.6]
b. 16 Oct 1785 d. 27 May 1807
11
Altheda Jones
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.2.7]
b. 27 Oct 1787 d. 28 Mar 1790
11
Cynthia Jones
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.2.8]
b. 13 May 1791 d. 5 Jan 1827
11
Rachel Jones
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.2.9]
b. 23 Apr 1793 d. 3 May 1823
10
David Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.3]
b. 27 Jun 1751 d. 14 May 1777
Bulah Johnson
b. 1750
11
Azubah Dagget
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.3.1]
b. 15 Mar 1774
Daniel Town
b. 1774
12
Betsy Town
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.3.1.1]
b. 1795 d. 13 Feb 1890 [
=>
]
Azubah Wheelock
b. 15 Jan 1745 d. 8 Feb 1804
11
Lyman Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.3.2]
b. 22 Aug 1775 d. 30 Apr 1870
Sarah West Hathaway
b. 22 Feb 1785
12
Catherine H Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.3.2.1]
b. 27 Aug 1807 d. 19 Jan 1890 [
=>
]
12
Clarissa Amanda Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.3.2.2]
b. 22 Oct 1810 d. 7 Jan 1879 [
=>
]
12
Pardon Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.3.2.3]
b. 14 Feb 1818 d. 1 Apr 1825
11
David Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.3.3]
b. 31 Jan 1776 d. 28 Sep 1861
Hannah Moffett
b. 7 Jan 1776 d. 31 Jan 1810
12
Sally Learned Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.1]
b. 13 Apr 1799 d. Bef 1834
12
Azubah Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.2]
b. 8 Mar 1802 d. 3 May 1881 [
=>
]
12
Erasmus Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.3]
b. 13 Mar 1804
12
Asahel Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.4]
b. 15 Feb 1807 d. 13 Mar 1890 [
=>
]
12
Rheuphemia Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.5]
b. 19 Oct 1809
Elizabeth Tobey
b. 22 Nov 1791 d. 1862
12
Eli Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.6]
b. 7 Feb 1815 d. Abt 1815
12
Polly W Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.7]
b. 25 Feb 1818
12
Maria Keziah Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.8]
b. 20 Apr 1820 d. 2 Dec 1883 [
=>
]
12
Lyman Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.9]
b. 22 Feb 1822 d. 26 Mar 1902 [
=>
]
12
Avery Tobey Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.10]
b. 16 Dec 1824 d. Aft 1880 [
=>
]
12
David Janson Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.11]
b. 4 May 1827 d. 30 Dec 1894 [
=>
]
12
Cordelia Flavilla Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.12]
b. 3 Feb 1831 d. Aft 1900 [
=>
]
12
Elizabeth Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.3.3.13]
b. Dec 1833
10
Hannah Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.4]
b. 23 Dec 1753
10
Martha Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.5]
b. 2 Jun 1755
Edward Wheelock
b. 1754
11
Relief Wheelock
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.5.1]
b. 2 Sep 1777
11
Silas Wheelock
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.5.2]
b. 20 Apr 1781 d. 30 Oct 1851
Rena Baldwin
b. 26 Feb 1778 d. 28 Jun 1833
12
Lewis Wheelock
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.1]
b. 5 Dec 1807 d. 24 Dec 1881 [
=>
]
12
Olive Wheelock
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.2]
b. 9 Apr 1806
12
Albert Wheelock
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.3]
b. 3 Jan 1805 d. 8 Jun 1875 [
=>
]
12
Scinda Wheelock
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.4]
b. 16 Sep 1809 d. 14 Oct 1845
12
Silas B Wheelock
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.5]
b. 6 Jun 1811 d. 16 Nov 1897 [
=>
]
12
John Homer Wheelock
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.6]
b. 26 May 1813 d. 28 Mar 1887 [
=>
]
12
Harmon Wheelock
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.7]
b. 13 Mar 1815 d. 1892
12
Nancy B Wheelock
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.8]
b. 17 Sep 1817 d. 20 Dec 1842
12
Joseph S Wheelock
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.9]
b. 1 Nov 1819 d. 21 Apr 1902 [
=>
]
12
Zenas S Wheelock
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.10]
b. 29 Aug 1821 d. 25 May 1844
12
James Wheelock
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.11]
b. 4 Jul 1824
12
Sophronia Wheelock
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.5.2.12]
b. 25 Oct 1826
+
Sarah Hurlbut
b. 21 Mar 1790 d. 1855
11
Lynda Wheelock
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.5.3]
b. 15 Apr 1783
11
Reuben Wheelock
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.5.4]
b. 23 Jul 1785 d. 29 Jul 1833
Rosanna Smiley
b. 5 Jun 1783 d. 30 Apr 1874
12
Agusta Wheelock
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.5.4.1]
b. Abt 1806
12
Gillman Wheelock
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.5.4.2]
b. Abt 1808
12
Sarah Wheelock
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.5.4.3]
b. Abt 1810
12
Eliza Ann Wheelock
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.5.4.4]
b. Abt 1812
12
Laurane Wheelock
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.5.4.5]
b. 1 Sep 1814 d. 24 Mar 1884 [
=>
]
12
Emmons Howe Wheelock
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.5.4.6]
b. 17 May 1817 d. 27 Apr 1899 [
=>
]
12
Caroline Wheelock
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.5.4.7]
b. 29 Sep 1819
12
Andrew Jackson Wheelock
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.5.4.8]
b. 1 Jun 1822 d. 31 May 1915 [
=>
]
12
James Loren Wheelock
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.5.4.9]
b. 28 Feb 1825 d. 6 Dec 1900 [
=>
]
10
Aaron Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.6]
b. 12 Mar 1757 d. 3 Jun 1759
10
Lidia Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.7]
b. 4 Oct 1758 d. 23 Mar 1836
Naham Lamb
b. 13 Jul 1759 d. 22 May 1842
11
Amasa Lamb
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.7.1]
b. 24 Jul 1786 d. 12 Jun 1815
11
Linda Lamb
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.7.2]
b. 14 Oct 1788
+
Caleb Knight
b. 16 Sep 1780
11
Patee Lamb
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.7.3]
b. 10 Jan 1791
11
Nahum Lamb
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.7.4]
b. 4 Aug 1793
11
Lydia Lamb
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.7.5]
b. 3 Feb 1796
11
Jason Lamb
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.7.6]
b. 9 Oct 1798 d. 2 Aug 1873
Nancy Cruver
b. 5 Nov 1804 d. 14 Nov 1843
12
Salem Towne Lamb
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.7.6.1]
b. 15 Oct 1823
12
George Washington Lamb
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.7.6.2]
b. 1825
12
Erastus Wallace Lamb
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.7.6.3]
b. 1826
12
Melinda Mary Lamb
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.7.6.4]
b. 1829
12
Leonard Lamb
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.7.6.5]
b. 1830 d. 1858
Melinda W Harmon
b. 17 Apr 1810 d. 31 Aug 1883
12
Ellen E Lamb
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.7.6.6]
b. 1846 d. Bef 1923 [
=>
]
12
Asenath H Lamb
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.7.6.7]
b. Abt 1849 d. Bef 1923
12
Kate Lamb
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.7.6.8]
b. 19 Dec 1853 d. 11 Jul 1936 [
=>
]
11
Gerson Lamb
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.7.7]
b. 8 Aug 1800 d. 13 Nov 1885
Lois Fisk Bacon
b. 11 Nov 1801 d. 4 Sep 1884
12
Norval Bacon Lamb
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.7.7.1]
b. 17 Apr 1827
12
Alvan Naham Lamb
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.7.7.2]
b. 27 Jul 1828
12
Edwin Dagget Lamb
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.7.7.3]
b. 18 Jul 1832
12
Henry Gersom Lamb
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.7.7.4]
b. 27 Feb 1834 [
=>
]
12
Theodore Fiske Lamb
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.7.7.5]
b. 2 Sep 1836
12
Charles Francis Lamb
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.7.7.6]
b. 15 Mar 1838
11
Washington Lamb
[1.1.2.3.1.1.1.4.2.7.8]
b. 6 May 1803
9
William Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3]
b. 15 Aug 1727 d. 15 Jan 1813
Thankful Gleason
b. 17 Jun 1738 d. 28 Dec 1813
10
Asa Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.1]
b. 7 Jul 1760 d. Abt 1830
Waitstill Monroe
b. 2 Jan 1764
11
Asel Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.1.1]
b. 16 Aug 1798 d. 6 Jan 1848
Elizabeth Barnes
b. 1804 d. 1 Jul 1891
12
Ann Elizabeth Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.1.1.1]
b. 13 Mar 1829 d. 21 Feb 1901 [
=>
]
12
Jefferson Loren Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.1.1.2]
b. 1 Jan 1838 d. 16 Jun 1919 [
=>
]
12
Julia Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.1.1.3]
b. 28 May 1837 d. 22 Apr 1921 [
=>
]
12
Elisha S Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.1.1.4]
b. 1839
12
Electa Elizabeth Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.1.1.5]
b. Sep 1844 [
=>
]
12
Mary Louisa Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.1.1.6]
b. 1847 [
=>
]
10
Anna Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.2]
b. 11 Sep 1762 d. Aft 1788
William Estey
b. 9 Aug 1759 d. 1843
11
Nabby Estey
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.2.1]
b. 8 Jul 1791
11
Fanny Estey
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.2.2]
b. 28 Mar 1793
11
Betsey Estey
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.2.3]
b. 26 Apr 1795
11
Anna Estey
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.2.4]
b. 25 Aug 1797
11
Gilman Estey
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.2.5]
b. 14 Oct 1799 d. 14 Oct 1877
+
Louisa Thompson
b. 29 Apr 1819 d. 22 Feb 1885
11
Caroline Estey
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.2.6]
b. 27 Dec 1801
+
George Rice
b. 1807
10
Phineas Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.3]
b. 22 Aug 1764
Betsey Wilson
b. 1769 d. 11 Aug 1791
11
William Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.3.1]
b. 21 Dec 1788 d. 2 Jun 1818
Clarissa Wait
b. 1791 d. 1862
12
William Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.3.1.1]
b. 1813 d. 16 May 1860
12
Clarissa Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.3.1.2]
b. 6 Mar 1815 d. 10 Nov 1890 [
=>
]
12
George Wait Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.3.1.3]
b. 30 Jun 1818 d. 25 Jun 1884 [
=>
]
12
Eliza Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.3.1.4]
b. 2 Oct 1817 [
=>
]
11
Artemas Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.3.2]
b. 17 Jul 1790 d. 1835
Sally Smith
b. Abt 1792
12
Daughter Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.3.2.1]
b. Abt 1806
12
Daughter Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.3.2.2]
b. Abt 1808
12
Daughter Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.3.2.3]
b. Abt 1810
Marcy Pierce
b. 6 Aug 1771 d. 29 Jun 1850
11
Polly Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.3.3]
b. 6 Aug 1795 d. 6 Aug 1802
11
Hiram Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.3.4]
b. 9 Aug 1797 d. 1 Jan 1832
11
Betsey Dagget
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.3.5]
b. 31 Dec 1799 d. 1877
Broughton Knight
b. 25 Feb 1798 d. 4 Feb 1854
12
Allona B Knight
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.3.5.1]
b. Abt 1833 d. 17 Dec 1869
12
Phila Knight
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.3.5.2]
b. Apr 1836
12
George P Knight
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.3.5.3]
b. Aug 1840
11
Hollis Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.3.6]
b. 4 Nov 1802 d. 1882
Flora Jackman
b. Abt 1806
12
Frederick Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.3.6.1]
b. Abt 1826
12
Daughter Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.3.6.2]
b. Abt 1828
11
Lewis Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.3.7]
b. 15 Aug 1804
Harriet Haughton
b. 7 Aug 1807 d. 10 Aug 1866
12
Hiram Sibley Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.3.7.1]
b. 3 Feb 1833 d. 25 Nov 1861
12
Carolina Louisa Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.3.7.2]
b. 7 Jun 1837 d. 14 Feb 1339
12
Henry Talmadge Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.3.7.3]
b. 8 Feb 1840 [
=>
]
12
Charles Prentice Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.3.7.4]
b. 5 Oct 1843 d. 14 Jan 1846
12
Charles Lewis Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.3.7.5]
b. 14 Jan 1851 d. 25 Feb 1869
11
Prentis Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.3.8]
b. 25 Aug 1807 d. 29 Oct 1881
11
Mary Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.3.9]
b. 1809 d. 1841
Daniel Pierce
b. 1808
12
Darwin Pierce
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.3.9.1]
b. Abt 1836
12
Horace Pierce
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.3.9.2]
b. Abt 1838
11
Louisa Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.3.10]
b. 10 Dec 1812
Moses Knapp Pratt
b. 1 Jan 1813 d. 15 Mar 1884
12
Frederic Knight Pratt
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.3.10.1]
b. 25 May 1843 [
=>
]
10
Nathaniel Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.4]
b. 1766 d. 16 Jun 1852
Electa Roberts
b. 12 Dec 1771 d. 27 Oct 1856
11
Harry Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.4.1]
b. 1793 d. 14 Nov 1869
Julia Crane
b. 1797 d. 25 Dec 1890
12
Julia Ann Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.4.1.1]
b. 29 Jul 1820
12
Harry Crane Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.4.1.2]
b. 24 Dec 1821 [
=>
]
12
Royal Montraville Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.4.1.3]
b. 9 Sep 1823 [
=>
]
12
Carlos Manson Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.4.1.4]
b. 1 Mar 1827
12
Oscar Fitzwilliam Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.4.1.5]
b. 11 May 1833 d. Aft 1880 [
=>
]
11
Shubael Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.4.2]
b. 1797
11
Orville Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.4.3]
b. 1799
11
Celista Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.4.4]
b. 1801 d. 6 Jan 1862
11
Phineas Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.4.5]
b. 1802
11
Phinehas Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.4.6]
b. 9 Aug 1802 d. 30 Oct 1877
Emeline Boynton
b. 29 Jul 1807 d. 6 Feb 1881
12
Pemelia Anne Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.4.6.1]
b. 17 Apr 1829 d. 5 Jul 1883
12
Hallis Boynton Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.4.6.2]
b. 28 Dec 1830 d. 14 Feb 1835
12
Lillian Sarah Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.4.6.3]
b. 3 Dec 1832 d. 20 Oct 1861 [
=>
]
12
May Miriah Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.4.6.4]
b. 10 Feb 1836
12
Mary M Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.4.6.5]
b. 10 Feb 1836
12
Harriet B Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.4.6.6]
b. 11 Sep 1837
12
Joseph Nathaniel Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.4.6.7]
b. 17 Nov 1839 d. 24 Mar 1902
12
Emeline Arethusa Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.4.6.8]
b. 25 Sep 1841 d. 15 Oct 1910 [
=>
]
12
Loretta Lamar Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.4.6.9]
b. 27 May 1844
12
Ellen Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.4.6.10]
b. 1 Nov 1846
12
Abbie Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.4.6.11]
b. 17 Apr 1848
11
Nathaniel Daggett, Jr
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.4.7]
b. 1804
11
Alpheus Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.4.8]
b. 1807
11
Samuel Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.4.9]
b. 1810
11
Philarmon Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.4.10]
b. 1812
11
Amos Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.4.11]
b. 1814
11
Electa Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.4.12]
b. 1816
10
Susan Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.5]
b. Abt 1768
John Rice
b. 1764 d. 1841
11
Nancy Rice
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.5.1]
b. 1789
+
Luther Denison
b. Abt 1787
+
Jeremiah Robbins
b. Abt 1785
11
John Rice
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.5.2]
b. 1791 d. Aft 1824
Eliza Burke
b. 29 May 1797
12
Ebed Burke Rice
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.5.2.1]
b. Abt 1824
11
Mary "Polly" Rice
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.5.3]
b. 1793 d. 1854
Samuel Nichols
b. 1772
12
Caroline E Nichols
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.5.3.1]
b. 1818 d. 3 Aug 1903 [
=>
]
11
Lewis Rice
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.5.4]
b. 1796 d. 1835
11
Louisa Rice
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.5.5]
b. 1798
+
Gilman Esty
11
Fannie Rice
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.5.6]
b. 1800 d. Aft 1821
Tyler Curtis Knight
b. 23 Aug 1797 d. 22 Apr 1855
12
Lucretia Knight
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.5.6.1]
d. 22 Apr 1855
11
Lucinda Rice
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.5.7]
b. 1802
+
John Bryant
b. Abt 1800
11
Horace Rice
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.5.8]
b. 1804
11
Emily Rice
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.5.9]
b. 1809
+
Thurman Richardson
b. Abt 1805
11
Susan Rice
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.5.10]
b. 1811
+
Calvin B Meade
b. Abt 1807
11
George Rice
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.5.11]
b. 1807
+
Caroline Estey
b. 27 Dec 1801
10
Hannah Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.6]
b. 1770
+
Horton
10
Sarah Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.7]
b. Abt 1772
10
Amos Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.8]
b. Abt 1772
10
Daughter Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.3.9]
b. Abt 1774
+
William Ide
9
Arthur Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4]
b. 30 Jan 1730 d. 23 Aug 1775
Mehitable King
b. 8 May 1731 d. 13 Mar 1809
10
Arthur Daggett, Jr
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.1]
b. 23 Apr 1751 d. 25 Aug 1835
Lucy Cutler
b. 17 Apr 1749 d. 23 Feb 1813
11
Arthur Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.1.1]
b. 13 Sep 1774 d. 11 Jan 1855
Azuba Haskell
b. 8 Mar 1768
12
Arthur Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.1.1.1]
b. 4 Apr 1803
12
Freeman Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.1.1.2]
b. 20 Jun 1807 [
=>
]
11
Stephen Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.1.2]
b. 7 Mar 1776 d. 22 Dec 1810
Mary Doty
b. 13 Aug 1781 d. 15 Mar 1855
12
Lucy Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.1.2.1]
b. 28 Jan 1805 [
=>
]
12
Catharine Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.1.2.2]
b. 16 Jan 1807 bur. 1887 [
=>
]
12
James Sullivan Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.1.2.3]
b. 20 Sep 1808 [
=>
]
12
Marietta Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.1.2.4]
b. 9 Sep 1809 d. 26 Oct 1840
11
John Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.1.3]
b. 22 Dec 1777 d. 26 Aug 1820
Loruhanah Nealy
b. 5 Aug 1782 d. 1814
12
Nealy Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.1.3.1]
b. 17 Apr 1803 d. 24 Aug 1824
12
Katherine Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.1.3.2]
b. 16 Jan 1807 d. 1887 [
=>
]
12
John Scott Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.1.3.3]
b. 22 Feb 1808 d. 14 Jan 1890
12
Orpha Edson Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.1.3.4]
b. 24 May 1810 d. 9 Jun 1875 [
=>
]
Abigail Durfee
b. 1780 d. Aug 1820
12
Stephen Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.1.3.5]
b. 11 Oct 1816 d. 1833
12
Simeon Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.1.3.6]
b. 14 Aug 1818 d. 23 Jun 1898 [
=>
]
11
Simeon Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.1.4]
b. 11 Jun 1779 d. 25 Jan 1823
+
Sallie Putnam
b. 1782
11
Polly Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.1.5]
b. 14 Feb 1781 d. 1 Nov 1813
Amasa Bancroft
b. 19 Mar 1778 d. 6 Feb 1812
12
Lucy Bancroft
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.1.5.1]
b. 30 Mar 1802 [
=>
]
12
Nancy Bancroft
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.1.5.2]
b. 1804
12
Cornelius Watrous Bancroft
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.1.5.3]
b. 1808 d. 22 Jan 1856
12
Carlos Bancroft
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.1.5.4]
b. 20 Mar 1809 d. 24 Oct 1876 [
=>
]
12
Amasa Bancroft
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.1.5.5]
b. 4 Mar 1811
11
Cate Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.1.6]
b. 4 Apr 1786
11
Lucy Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.1.7]
b. 27 Sep 1789
11
Mehitable Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.1.8]
b. 1793 d. 14 Aug 1844
10
Mehetabel Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.2]
b. 10 Oct 1752 d. 20 Apr 1834
Jonathon Rich
b. 20 Jul 1747 d. 28 Aug 1828
11
Reuben Rich
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.2.1]
b. 26 Apr 1775
11
Simeon Rich
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.2.2]
b. 6 Mar 1780 d. 11 Sep 1855
Patty Ward
b. 19 Dec 1779
12
Gibert Rich
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.2.2.1]
b. 29 Nov 1806 [
=>
]
12
Loisa Rich
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.2.2.2]
b. Bef 1809
12
Diantha Rich
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.2.2.3]
b. 1 Jun 1817 [
=>
]
12
Erastus Rich
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.2.2.4]
b. Sep 1809
12
Lucetta Rich
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.2.2.5]
b. 8 Mar 1820 d. Aft 1870
12
Louisa Rich
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.2.2.6]
b. 6 Apr 1812
12
Lorinda Rich
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.2.2.7]
b. 3 Nov 1814 d. Sep 1844
11
Arthur Rich
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.2.3]
b. 13 Oct 1777
+
Ruby Titus
b. Abt 1781
11
Cynthia Rich
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.2.4]
b. Abt 1779
+
Dexter Carbin
b. Abt 1775
11
Jonathan Rich, Jr
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.2.5]
b. 19 Nov 1782
11
Paul Rich
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.2.6]
b. 16 Aug 1785
11
Barnabas Rich
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.2.7]
b. 13 Oct 1787
+
Lucy Nichols
b. 17 May 1796 d. 20 Feb 1868
10
Simeon Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.3]
b. 7 Mar 1757 d. 9 May 1819
Anna Dean
b. 1759 d. 9 May 1819
11
Nancy Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.3.1]
b. Abt 1779
+
Amos Putney
b. 10 Feb 1789
11
Simeon Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.3.2]
b. 1780 d. 17 Jun 1854
Susan Towle
b. 1795 d. 15 Jul 1874
12
Elias Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.3.2.1]
b. 1816
12
Lydia A Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.3.2.2]
b. 1819
12
Susan T Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.3.2.3]
b. 1823 d. 22 Oct 1907
12
Mary Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.3.2.4]
b. 1825 d. 26 May 1863
12
Simeon Orval Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.3.2.5]
b. 1827 [
=>
]
11
Sally Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.3.3]
b. 1782
11
Son Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.3.4]
b. Abt 1784
11
Nathaniel Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.3.5]
b. 12 Jul 1785 d. Abt 1827
Maltilda Farwell
b. 17 Jun 1794 d. 4 Oct 1883
12
Catherine Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.3.5.1]
b. 20 Jun 1811 d. 19 Nov 1861
12
Lorenzo Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.3.5.2]
b. 14 Feb 1813 d. 24 Nov 1889 [
=>
]
12
John Farwell Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.3.5.3]
b. 2 Apr 1816 d. 21 Jun 1899 [
=>
]
12
Derius Dagget
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.3.5.4]
b. 9 Jan 1819 d. 30 Jan 1819
12
Sarah Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.3.5.5]
b. 31 Jul 1822 d. May 1922
12
Sophia Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.3.5.6]
b. 9 Oct 1825
11
Caleb C Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.3.6]
b. Abt 1790 d. 23 Dec 1879
11
Artemas Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.3.7]
b. 17 Jul 1790
11
Mary Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.3.8]
b. 10 Nov 1795 d. 18 Aug 1864
Henry C Hooker
b. 5 Jul 1791 d. 17 Mar 1885
12
Amelia Prentice Hooker
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.3.8.1]
b. 26 Aug 1817 d. 23 Dec 1817
12
Julia Worthington Hooker
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.3.8.2]
b. 15 Nov 1818 d. 14 Oct 1915 [
=>
]
12
George Prentice Hooker
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.3.8.3]
b. 31 May 1820 d. 1912 [
=>
]
12
Charles Gay Hooker
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.3.8.4]
b. 12 Nov 1822 d. 18 Nov 1905 [
=>
]
12
Ansen Carey Hooker
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.3.8.5]
b. 2 Sep 1825 d. 4 Jul 1832
12
Henry Clay Hooker
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.3.8.6]
b. 10 Jan 1828 d. 5 Dec 1907 [
=>
]
12
Almira Ann Hooker
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.3.8.7]
b. 28 May 1830 d. 5 Jul 1904 [
=>
]
12
Minerva Sophia Hooker
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.3.8.8]
b. 11 Sep 1832 d. 13 Nov 1921 [
=>
]
12
Ansen Carey Hooker
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.3.8.9]
b. 1 May 1835 d. 8 Nov 1915
12
John Daggett Hooker
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.3.8.10]
b. 10 May 1838 d. 24 May 1911 [
=>
]
12
Mary Rosella Hooker
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.3.8.11]
b. 12 Jan 1841 d. May 1925
10
Gideon Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.4]
b. 21 Dec 1759 d. 27 Aug 1838
Elizabeth Pratt
b. 22 Jul 1759 d. 1822
11
Gardner Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.4.1]
b. 12 Oct 1788 d. Oct 1843
Eunice White
b. 23 Oct 1787 d. 15 Jun 1833
12
Sophronia Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.4.1.1]
b. 15 Jul 1812 d. 14 Oct 1888
12
Diana Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.4.1.2]
b. Dec 1814 d. 1866
12
Eunice Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.4.1.3]
b. Dec 1816 d. 1841
12
Elizabeth Ann Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.4.1.4]
b. 4 Jul 1818
12
William Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.4.1.5]
b. 1821 d. May 1835
12
Gardner Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.4.1.6]
b. Abt 1823
12
Arthur Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.4.1.7]
b. Abt 1825
12
Harriet Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.4.1.8]
b. Apr 1827 d. Oct 1876 [
=>
]
12
Ester Smith Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.4.1.9]
b. 27 Sep 1829 [
=>
]
12
Rollin Mallory Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.4.1.10]
b. 22 Feb 1831
11
William King Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.4.2]
b. 24 Aug 1792 d. 6 Feb 1862
+
Betsy Johnson
b. 20 Sep 1791 d. 6 Nov 1835
11
Nancy Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.4.3]
b. 1793
11
Harvey Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.4.4]
b. 1797
11
Gideon Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.4.5]
b. 1800
10
Betty Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.5]
b. 3 Feb 1763 d. 28 Jul 1829
Thomas Todd
b. 17 Nov 1760 d. 20 Nov 1848
11
Billy Todd
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.5.1]
b. 15 Jul 1783 d. 1871
11
Lavina Todd
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.5.2]
b. 1 Sep 1785 d. Mar 1835
11
Orinda Todd
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.5.3]
b. 1 Sep 1787 d. 12 Jun 1872
Jeremiah Dewey
b. 31 Jan 1788 d. 29 Jul 1849
12
Harvey Dewey
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.5.3.1]
b. 1814
12
Elizabeth "Betsey" Dewey
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.5.3.2]
b. 6 Apr 1814 d. 6 Apr 1848 [
=>
]
12
Hiram T Dewey
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.5.3.3]
b. 13 Jul 1816 d. 25 May 1898 [
=>
]
12
Washington Dewey
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.5.3.4]
b. 10 Sep 1818 d. 16 Mar 1896 [
=>
]
12
Royal Dewey
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.5.3.5]
b. 1820
12
Orinda Dewey
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.5.3.6]
b. 1822
11
Diantha Todd
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.5.4]
b. 1 May 1791 d. 27 Dec 1824
11
Elmer Todd
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.5.5]
b. 16 Jun 1793 d. 13 Oct 1812
11
Relief Todd
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.5.6]
b. 11 Mar 1798 d. 19 Oct 1885
Joseph Moulton
b. 7 Feb 1798 d. 10 Feb 1873
12
Anne Moulton
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.5.6.1]
b. 31 Mar 1822 [
=>
]
12
James Thompson Moulton
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.5.6.2]
b. 1 Nov 1823 [
=>
]
12
Charles Henry Moulton
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.5.6.3]
b. 6 Feb 1829 [
=>
]
12
John Todd Moulton
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.5.6.4]
b. 7 Aug 1838 d. 10 Feb 1873 [
=>
]
12
Walter Scott Moulton
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.5.6.5]
b. 9 Aug 1840 d. 17 Jun 1874 [
=>
]
11
Alanson Todd
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.5.7]
b. 5 Sep 1800 d. 13 Jul 1882
Lydia Wheeler
b. 24 Oct 1800 d. 14 Oct 1877
12
Elmor Todd
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.5.7.1]
b. 27 Feb 1828 d. 16 Jul 1829
12
Son Todd
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.5.7.2]
b. 4 Jul 1829 d. 4 Jul 1829
12
Cornelia Todd
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.5.7.3]
b. 15 May 1831 d. 14 Mar 1877
12
Cyrus Wheeler Todd
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.5.7.4]
b. 5 Jun 1833 d. 25 Dec 1903 [
=>
]
12
Hiram Todd
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.5.7.5]
b. 30 Apr 1836 d. 20 Jun 1840
12
Helen Mar Todd
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.5.7.6]
b. 1 Jul 1838 d. 27 Jan 1923
11
Charles Todd
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.5.8]
b. 27 Sep 1802 d. 8 Apr 1804
11
Hiram Todd
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.5.9]
b. 18 Nov 1795 d. 11 Jul 1849
Lydia Church
b. 8 Jan 1802 d. 26 Dec 1871
12
Caroline Todd
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.5.9.1]
b. 26 Feb 1830 d. Mar 1833
12
Frances Todd
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.5.9.2]
b. 12 Sep 1832 [
=>
]
12
Hiram Church Todd
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.5.9.3]
b. 26 Jun 1835 [
=>
]
12
Martha Todd
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.5.9.4]
b. 21 Sep 1837 d. 1 Sep 1847
12
Walter Wilson Todd
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.5.9.5]
b. 27 Feb 1840 d. 18 Oct 1899 [
=>
]
12
Edgar Todd
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.5.9.6]
b. Abt 1842
11
Solomon Todd
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.5.10]
b. 15 Oct 1804 d. 17 Oct 1832
11
Betsey Todd
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.5.11]
b. 8 Nov 1806
Austin Bruce
b. 19 Dec 1803
12
Frances Elizabeth Bruce
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.5.11.1]
b. 6 Sep 1830 d. 27 Sep 1915 [
=>
]
10
Tamar Daggett
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.6]
b. 24 Mar 1767 d. 23 Oct 1820
Eliphalet Holman
b. Abt 1761 d. 30 May 1838
11
Catharine Holman
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.6.1]
b. 3 Dec 1789 d. 11 Aug 1864
John Cummings
b. 2 May 1786 d. 30 Oct 1832
12
Lucy Daggett Cummings
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.6.1.1]
b. 18 Feb 1808 d. 9 Apr 1818
12
Tamar Holman Cummings
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.6.1.2]
b. 19 Sep 1810 d. 5 Nov 1830
12
Eliphalet H Cummings
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.6.1.3]
b. 2 Dec 1813 d. 15 Nov 1875 [
=>
]
12
Daniel Cummings
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.6.1.4]
b. 15 May 1816 d. 15 Nov 1875
12
Preston Cummings
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.6.1.5]
b. 10 Jun 1818 d. 14 Sep 1868
12
Lucy Cummings
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.6.1.6]
b. 10 Oct 1819 d. 27 Sep 1821
12
Catharine Cummings
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.6.1.7]
b. 1 Oct 1821 d. 27 Nov 1896
12
Diantha Cummings
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.6.1.8]
b. 29 Mar 1823 d. 21 Sep 1860
12
John Cummings
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.6.1.9]
b. 25 Dec 1824 d. 20 Jul 1898
12
Mary Cummings
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.6.1.10]
b. 22 Jul 1827 d. 1904
12
Candace H Cummings
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.6.1.11]
b. 1829
12
Lucy Tamar Cummings
[1.1.2.3.1.1.1.4.4.6.1.12]
b. 16 Oct 1831 d. 30 Sep 1833
8
Samuel Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.5]
b. 16 May 1697 d. Dec 1730
Martha Dike
b. Abt 1700 d. 5 Oct 1775
9
Samuel Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.5.1]
b. 1724 d. 31 Aug 1801
9
Nathaniel Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.5.2]
b. Abt 1725 d. 24 May 1811
Ruth Bradish
b. 7 May 1722 d. 12 Aug 1810
10
Ruth Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.5.2.1]
b. 9 Apr 1745 d. 30 Nov 1814
Benoni Benson
b. 11 Jul 1747 d. 1803
11
John Benson
[1.1.2.3.1.1.1.5.2.1.1]
b. 1789
10
Martha Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.5.2.2]
b. 17 Apr 1747 d. 4 Mar 1775
10
Mary Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.5.2.3]
b. 1 Sep 1749
10
Eunice Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.5.2.4]
b. 27 Feb 1752 d. Mar 1775
10
Nathan Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.5.2.5]
b. 22 Jun 1754 d. 22 Feb 1755
10
Stephen Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.5.2.6]
b. 21 Sep 1756
10
Nathaniel Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.5.2.7]
b. 20 Apr 1759 d. 25 Aug 1775
10
Jonas Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.5.2.8]
b. 7 Mar 1762 d. 5 Feb 1834
9
Lucy Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.5.3]
b. 16 Apr 1726 d. 13 Dec 1821
9
Jeremiah Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.5.4]
b. 31 Dec 1728 d. Abt 1807
9
Benjamin Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.5.5]
b. 27 Feb 1731 d. Aft 27 Jan 1794
8
William Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.6]
c. 7 Sep 1700 d. 18 Sep 1763
Sarah
b. Abt 1703
9
William Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.6.1]
b. 4 May 1727
9
Elijah Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.6.2]
b. Abt 1728
9
Sarah Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.6.3]
b. 23 Aug 1730 d. 13 Jun 1816
9
Daniel Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.6.4]
b. 31 Jan 1732
9
David Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.6.5]
b. 3 Oct 1736
8
Benjamin Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.7]
b. 19 Sep 1703 d. 2 Nov 1780
Pricilla Rich
b. 28 Sep 1706 d. 1 Feb 1782
9
Priscilla Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.7.1]
b. 5 Aug 1725 d. 6 Feb 1737
9
Benjamin Sibley, Jr
[1.1.2.3.1.1.1.7.2]
b. 17 Aug 1727 d. 12 Nov 1789
9
Zuruiah Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.7.3]
b. 31 Aug 1729 d. Aft 1770
9
Susanna Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.7.4]
b. 31 Aug 1733 d. 24 Apr 1810
9
Ezra Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.7.5]
b. 4 Aug 1738 d. 11 Oct 1762
9
Aaron Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.7.6]
b. 2 Jul 1740 d. 1776
9
Moses Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.7.7]
b. 9 May 1743 d. 16 Sep 1760
9
Joseph Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.7.8]
b. 19 Aug 1745
9
Samuel Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.7.9]
b. 14 Jun 1747 d. 1841
9
Jonathan Sibley
[1.1.2.3.1.1.1.7.10]
b. 4 Mar 1750 d. 31 Jul 1828
6
Elizabeth Black
[1.1.2.3.1.2]
b. Abt 1632
Sir Humphrey Gilbert
b. 1616 d. Bef 30 Mar 1658
7
Martha Gilbert
[1.1.2.3.1.2.1]
b. Abt 1651 d. Bef 4 Feb 1692
7
Abigail Gilbert
[1.1.2.3.1.2.2]
b. Abt 1654 d. 1735
7
Esther Gilbert
[1.1.2.3.1.2.3]
b. 1654
7
John Gilbert
[1.1.2.3.1.2.4]
b. 1656 d. 17 Mar 1722
Elizabeth Kilham
b. 1657 d. 17 Mar 1722
8
Mary Gilbert
[1.1.2.3.1.2.4.1]
b. Abt 1681 d. 1681
8
Elizabeth Gilbert
[1.1.2.3.1.2.4.2]
b. Abt 1683
8
Daniel Gilbert
[1.1.2.3.1.2.4.3]
b. Abt 1685 d. 2 Nov 1723
Elisabeth Porter
b. Abt 1689 d. Jan 1789
9
Lydia Gilbert
[1.1.2.3.1.2.4.3.1]
b. 9 Dec 1711 d. Abt 1757
9
Mary Gilbert
[1.1.2.3.1.2.4.3.2]
b. 17 Sep 1721 d. 1760
9
Elizabeth Gilbert
[1.1.2.3.1.2.4.3.3]
c. 13 Nov 1713 d. 21 Aug 1751
Joseph Noyes
b. 14 Jul 1710 d. 1754
10
Elizabeth Noyes
[1.1.2.3.1.2.4.3.3.1]
b. 18 Dec 1735 d. 9 Jul 1829
Thomas Phillips
b. 7 Jun 1747 d. 9 Jul 1829
11
Rhoda Phillips
[1.1.2.3.1.2.4.3.3.1.1]
b. Abt 1770 d. 23 Nov 1825
Enoch King
b. 22 Jan 1770 d. 8 Oct 1853
12
Betsy King
[1.1.2.3.1.2.4.3.3.1.1.1]
b. 1789 d. 20 Mar 1863
12
Lydia King
[1.1.2.3.1.2.4.3.3.1.1.2]
b. Abt 1789 d. 16 May 1835
12
Lucy King
[1.1.2.3.1.2.4.3.3.1.1.3]
b. Abt 1789 d. 1790
12
Electa King
[1.1.2.3.1.2.4.3.3.1.1.4]
b. Abt 1791 d. Aft 1870
12
Otis King
[1.1.2.3.1.2.4.3.3.1.1.5]
b. 15 Mar 1793 d. 20 Mar 1863
12
Rachael King
[1.1.2.3.1.2.4.3.3.1.1.6]
b. Abt 1799 d. 1801
12
Polly Mary King
[1.1.2.3.1.2.4.3.3.1.1.7]
b. 18 Dec 1799 d. 28 Oct 1881
12
Moses King
[1.1.2.3.1.2.4.3.3.1.1.8]
b. 1803 d. 20 Mar 1863
12
Dorcas King
[1.1.2.3.1.2.4.3.3.1.1.9]
b. 3 May 1804 d. 6 Oct 1876
12
Thomas Jefferson King
[1.1.2.3.1.2.4.3.3.1.1.10]
b. 27 May 1806 d. 23 Sep 1876 [
=>
]
12
Enoch Edwin King
[1.1.2.3.1.2.4.3.3.1.1.11]
b. 1808 d. 23 Sep 1886
12
John Russell King
[1.1.2.3.1.2.4.3.3.1.1.12]
b. 16 Oct 1810 d. 28 Feb 1877
12
Rhoda King
[1.1.2.3.1.2.4.3.3.1.1.13]
b. 1811
11
Mary Phillips
[1.1.2.3.1.2.4.3.3.1.2]
b. 1 Oct 1774 d. 20 Apr 1844
11
Rachael Phillips
[1.1.2.3.1.2.4.3.3.1.3]
b. 1777 d. 9 Mar 1864
11
Russel Phillips
[1.1.2.3.1.2.4.3.3.1.4]
b. 31 Aug 1785 d. 15 Apr 1856
11
Caleb Phillips
[1.1.2.3.1.2.4.3.3.1.5]
b. Abt 1787
11
Moses Phillips
[1.1.2.3.1.2.4.3.3.1.6]
b. Abt 1789
11
Betsey Phillips
[1.1.2.3.1.2.4.3.3.1.7]
b. 1789 d. 1813
11
Dorcas Phillips
[1.1.2.3.1.2.4.3.3.1.8]
b. Abt 1789
10
Mary Noyes
[1.1.2.3.1.2.4.3.3.2]
b. 28 Dec 1737
10
Daniel Noyes
[1.1.2.3.1.2.4.3.3.3]
b. 10 Jun 1740 d. Abt 1824
10
Moses Noyes
[1.1.2.3.1.2.4.3.3.4]
b. 11 May 1743
9
Mercy Gilbert
[1.1.2.3.1.2.4.3.4]
c. 1 Apr 1716
9
Daniel Gilbert
[1.1.2.3.1.2.4.3.5]
c. 13 Apr 1718
9
Hannah Gilbert
[1.1.2.3.1.2.4.3.6]
c. 23 Dec 1722
8
Martha Gilbert
[1.1.2.3.1.2.4.4]
b. Abt 1688
8
Benjamin Gilbert
[1.1.2.3.1.2.4.5]
b. 1 Feb 1691 d. 24 Jun 1760
8
Joseph Gilbert
[1.1.2.3.1.2.4.6]
b. 1 Feb 1691 d. Mar 1763
8
Noah Gilbert
[1.1.2.3.1.2.4.7]
b. 21 Nov 1703 d. 22 Nov 1768
6
Lydia Black
[1.1.2.3.1.3]
b. 25 Dec 1636
6
Lydia Black
[1.1.2.3.1.4]
b. 3 Jun 1638 d. Bef 1748
6
John Black, Jr
[1.1.2.3.1.5]
b. 1642 d. 18 Aug 1700
5
Patrick Black
[1.1.2.3.2]
b. 28 Sep 1692
3
Gilbert Skene
[1.1.3]
b. Abt 1538 d. 1604
3
William Skene
[1.1.4]
b. Abt 1539 d. 29 Aug 1635
3
Patrick Skene
[1.1.5]
b. Abt 1540 d. 29 Aug 1635
3
Alexander Skene
[1.1.6]
b. Abt 1541 d. 1601