Home Page
|
What's New
|
Photos
|
Histories
|
Headstones
|
Reports
|
Surnames
Search
First Name:
Last Name:
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Suomalainen
Svenska
Alexander de Skene
1482 - 1507 (25 years)
Submit Photo / Document
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Submit Photo / Doc
Worksheet
Family
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Alexander de Skene
[1]
b. 1482 d. 1507
Agnes Forbes
b. 1482
2
Alexander de Skeen
[1.1]
b. 1498 d. 1573
Elizabeth Black
b. Abt 1495 d. 1573
3
Alexander Skene
[1.1.1]
b. 1517 d. 1604
Elizabeth Forbes
b. 1517
4
James Skeen
[1.1.1.1]
b. Abt 1536 d. 1605
4
Agnes Skeen
[1.1.1.2]
b. Abt 1537 d. 1693
John Black
b. Abt 1540 d. 1591
5
Alexander Black
[1.1.1.2.1]
b. Abt 1559
5
Agnes Black
[1.1.1.2.2]
b. Abt 1564
5
John Black
[1.1.1.2.3]
b. Abt 1565
Elizabeth Locart
b. 1570 d. 1641
6
John Black
[1.1.1.2.3.1]
b. Abt 1613 d. 1 Mar 1675
Susanna Freeman
b. Abt 1610 d. Aft 1645
7
Persis Black
[1.1.1.2.3.1.1]
b. Abt 1627 d. 20 Jul 1677
William Follett
b. Abt 1625
8
Susanna Follett
[1.1.1.2.3.1.1.1]
b. 1 Jun 1662
Joseph Sibley
b. 1655 d. 25 Apr 1711
9
Joseph Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.1]
b. 9 Nov 1685 d. 1754
Elizabeth Boutwell
b. 2 Mar 1683 d. Bef 1734
10
Joseph Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.1.1]
b. 6 Mar 1709 d. 22 Aug 1777
10
John Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.1.2]
b. 2 Aug 1711 d. 27 Nov 1778
10
James Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.1.3]
b. 7 May 1714
10
Elizabeth Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.1.4]
b. Abt 1716
10
Jonathan Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.1.5]
b. 11 Sep 1718 d. 30 Mar 1787
10
Hannah Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.1.6]
b. 27 Jun 1721
10
Susanna Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.1.7]
b. 24 Aug 1723
10
Mary Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.1.8]
b. 23 Sep 1725
9
John Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2]
b. 18 Sep 1687 d. 13 May 1741
Zerviah Gould
b. 20 Apr 1694 d. Bef 1741
10
Ebenezer Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.1]
b. 28 Feb 1717 d. 4 Mar 1790
Abigail Cummings
b. 3 May 1716 d. 27 Sep 1783
11
Stephen Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.1.1]
b. 12 Jul 1741 d. 25 Aug 1828
Thankful Taft
b. 25 May 1745 d. 26 Oct 1837
12
Joel Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.1.1.1]
b. 25 Apr 1766 d. 10 Apr 1839 [
=>
]
12
Lydia Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.1.1.2]
b. 2 Apr 1769 d. 27 Nov 1822 [
=>
]
11
Ebenezer Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.1.2]
b. 9 Oct 1745
Mary Chase
b. 15 Mar 1741 d. 1784
12
Sarah Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.1.2.1]
b. 19 Dec 1772
12
Lucy Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.1.2.2]
b. 2 Mar 1775
12
Eunice Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.1.2.3]
b. 1 Mar 1777
12
Elias Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.1.2.4]
b. 8 Aug 1779 d. 1856 [
=>
]
12
Ebenezer Sibley, Jr
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.1.2.5]
b. 18 Jan 1782 d. 15 Mar 1827 [
=>
]
12
Zadock Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.1.2.6]
b. 12 Oct 1785
12
Mary Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.1.2.7]
b. 1 Feb 1789 d. 24 Apr 1844
11
Abigail Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.1.3]
b. 22 Jan 1747
11
Peter Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.1.4]
b. 16 Sep 1749
11
Mary Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.1.5]
b. 20 Jan 1751
10
Stephen Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.2]
b. 1 Oct 1720
Mrs Sibley
b. Abt 1725
11
Elias Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.2.1]
b. Abt 1745
10
Bethiah Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.3]
b. 2 Oct 1724 d. 1 Jul 1756
Samuel Trask
b. 17 Dec 1721 d. 7 Mar 1790
11
John Trask
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.3.1]
b. 29 Sep 1744
11
Hannah Trask
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.3.2]
b. 10 Nov 1746
11
Sarah Trask
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.3.3]
b. 10 Sep 1753 d. 22 Aug 1830
Major Simon Tenney
b. 13 Sep 1746 d. 14 Aug 1838
12
Major Daniel Tenney
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.3.3.1]
b. 23 Nov 1773 [
=>
]
11
Samuel Trask, Jr
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.3.4]
b. 26 Aug 1749
Ruth Tenney
b. 16 Mar 1753 d. 27 Apr 1789
12
Samuel Trask, III
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.3.4.1]
b. 10 Dec 1773
12
Simon Trask
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.3.4.2]
b. 13 Jan 1775
12
Hannah Trask
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.3.4.3]
b. 4 Feb 1777
12
Stephen Trask
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.3.4.4]
b. 18 Feb 1779
12
Salley Trask
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.3.4.5]
b. 17 Jan 1784 d. 5 Feb 1819 [
=>
]
Allice Perry
b. Abt 1759
12
Talmon Trask
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.3.4.6]
c. 6 Oct 1799
12
Danforth Trask
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.3.4.7]
c. 27 Nov 1801
12
Dexter Trask
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.3.4.8]
c. 11 Aug 1807
12
Edwin Trask
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.3.4.9]
c. 29 Sep 1809
12
Angelina Trask
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.3.4.10]
c. 26 Oct 1811
11
Anne Trask
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.3.5]
b. 9 Oct 1757
10
Timothy Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4]
b. 2 Nov 1727 d. 6 Dec 1818
Ann Waite
b. 14 Oct 1733 d. 12 Mar 1791
11
John Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.1]
b. 19 May 1757 d. 8 Apr 1837
Betsey Hopkins
b. Abt 1754 d. 1790
12
George Champlin Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.1.1]
b. 1 Apr 1782 d. 31 Jan 1863
11
Timothy Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.2]
b. 19 Jun 1754 d. 26 Aug 1829
Mary
b. Abt 1756
12
Timothy Willard Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.2.1]
b. 11 Sep 1779 d. 11 Mar 1820 [
=>
]
12
Mary Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.2.2]
b. 5 Dec 1780
12
Anne Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.2.3]
b. 15 Jan 1782
12
Cyrus Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.2.4]
b. 6 Jan 1784 [
=>
]
12
Artemas Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.2.5]
b. 21 Apr 1786
12
Salome Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.2.6]
b. 13 Apr 1788 d. Aft 1880 [
=>
]
12
Benijamin Franklin Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.2.7]
b. 19 Jul 1790
12
Origen Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.2.8]
b. 1792 d. 1870 [
=>
]
11
Joshua Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.3]
b. 16 Nov 1755 d. 29 Sep 1774
11
Stephen Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.4]
b. 19 May 1757 d. 2 Jun 1759
11
Stephen Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.5]
b. 10 Nov 1759 d. 21 Apr 1829
11
Ebenezer Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.6]
b. 7 Apr 1761 d. 10 Sep 1839
Lydia Beach
b. 15 May 1766 d. 6 Mar 1834
12
John Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.6.1]
b. 3 Jul 1791 [
=>
]
12
Timothy Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.6.2]
b. 4 Feb 1803 d. 24 Sep 1880
11
Anna Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.7]
b. 15 Dec 1762 d. 17 Sep 1792
Samuel Hoyt
b. 24 Jan 1739 d. 22 Nov 1821
12
Lydia Hoyt
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.7.1]
b. 9 Apr 1779 d. Aft 1850 [
=>
]
12
Anna Hoyt
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.7.2]
b. 26 Sep 1781 d. 16 Sep 1865 [
=>
]
12
William Hoyt
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.7.3]
b. 24 Jul 1783 d. 19 Feb 1813 [
=>
]
12
Sarah Hoyt
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.7.4]
b. 13 Feb 1786 d. 14 Nov 1862 [
=>
]
11
Asa Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.8]
b. 29 Mar 1764 d. 25 Feb 1829
Irene Carpenter
b. 28 Jan 1766 d. 5 Oct 1846
12
Derick Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.8.1]
b. 22 May 1788 d. Abt 1846 [
=>
]
12
Sophia Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.8.2]
b. 5 Oct 1790 d. 4 Feb 1841 [
=>
]
12
Lucy Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.8.3]
b. 21 Jul 1792 d. 18 Jul 1795
12
Levi Waite Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.8.4]
b. 4 Mar 1801 d. 13 Aug 1844 [
=>
]
12
Mary Ann Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.8.5]
b. 18 Dec 1804 d. 18 Oct 1870 [
=>
]
12
George Ainsworth Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.8.6]
b. 9 Apr 1809 d. 1 Jun 1836
12
Daughter Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.8.7]
c. 1 Oct 1809 d. 1809
11
Jonathan Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.9]
b. 8 May 1766 d. 20 Feb 1823
Mary Davis
b. 24 Feb 1768 d. 23 Jun 1840
12
Davis Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.9.1]
b. 29 Nov 1788 d. 21 Nov 1828 [
=>
]
12
Mary Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.9.2]
b. 13 Apr 1792 d. 9 Nov 1844 [
=>
]
12
Jonathan W Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.9.3]
b. 13 Aug 1800 d. 26 Sep 1829 [
=>
]
11
Benjamin Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.10]
b. 29 Apr 1768 d. 2 Oct 1829
Zilpah Davis
b. 13 Apr 1771 d. 16 May 1824
12
Samuel Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.10.1]
b. 30 Nov 1792 d. 4 Mar 1858 [
=>
]
12
Patty Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.10.2]
b. 6 Feb 1799 d. 12 Jul 1805
12
Nancy Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.10.3]
b. 7 Feb 1806 d. 14 Feb 1806
12
Hiram Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.10.4]
b. 6 Feb 1807 d. 12 Jul 1888 [
=>
]
11
Soloman Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.11]
b. 17 Nov 1769
Sally Stockwell
b. 21 Jan 1774
12
Stephen Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.11.1]
b. 12 Dec 1792
12
Nancy Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.11.2]
b. 19 Jan 1797
12
Heister Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.11.3]
b. 19 Jun 1799
12
Lewis Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.11.4]
b. 8 Jul 1801
12
Stephen Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.11.5]
b. 26 Jul 1805 [
=>
]
12
Solomon Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.11.6]
b. 14 Jun 1808
12
John Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.11.7]
b. 20 Feb 1818 d. 17 Aug 1824
11
Polly Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.12]
b. 4 Dec 1771
Abner C Cummings
b. 9 Oct 1770 d. 1800
12
Nancy Cummings
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.12.1]
b. 5 Nov 1795 [
=>
]
12
Clarissa Cummings
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.12.2]
b. 18 Apr 1796 d. 1838 [
=>
]
11
Artamus Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.13]
b. 9 Jul 1773 d. 10 Aug 1777
11
Nahum Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.14]
b. 11 Sep 1775 d. 12 Sep 1796
11
Sally Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.15]
b. 6 Jun 1779 d. 21 Mar 1833
Amasa Cummings
b. 17 Jan 1778 d. 22 Mar 1836
12
Abner Cummings
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.15.1]
b. 1 Jan 1808
12
Sarah Ann Cummings
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.15.2]
b. 22 Oct 1812
12
Nahum Sibley Cummings
[1.1.1.2.3.1.1.1.2.4.15.3]
b. 7 Jan 1816
+
Hannah Amidon
b. Abt 1730 d. 5 Jun 1822
9
Jonathan Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.3]
b. 1 May 1690 d. Abt 1733
Mary Cutler
b. 19 Mar 1691 d. 1734
10
Martha Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.3.1]
b. 10 Jul 1731
9
Hannah Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.4]
c. 9 May 1695 d. 8 Feb 1731
Ebenezer Daggett
b. 22 Nov 1693 d. 8 Apr 1762
10
Ebenezer Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.1]
b. 13 Apr 1723 d. Bef 3 Aug 1761
10
Thomas Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.2]
b. 21 Apr 1725 d. 28 Nov 1758
Martha Stockwell
b. 25 Mar 1724
11
Captain John Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.2.1]
b. 15 Sep 1748 d. 8 Feb 1816
Mary Stevens
b. 1749
12
Thomas Dagget
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.2.1.1]
b. 5 Aug 1776 [
=>
]
12
John Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.2.1.2]
b. 14 Oct 1778 d. 6 Jan 1824 [
=>
]
12
Sarah Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.2.1.3]
b. 2 Apr 1780 d. 1873 [
=>
]
12
Simeon Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.2.1.4]
b. Abt 1782
12
Simon Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.2.1.5]
b. 1786 d. 1807
12
Captain Aaron Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.2.1.6]
b. 4 Mar 1787 d. 1 Feb 1862 [
=>
]
12
Mary Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.2.1.7]
b. 5 Jul 1789 [
=>
]
+
Sarah Jones
b. 26 Oct 1749 d. Bef 1775
11
Mary Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.2.2]
b. 29 Mar 1750 d. Aft 25 Sep 1826
Seth Corbett Jones
b. 21 Mar 1748 d. 14 Apr 1827
12
Samuel Jones
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.2.2.1]
b. 5 Aug 1773 d. 24 Aug 1846 [
=>
]
12
Aaron Jones
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.2.2.2]
b. 23 Mar 1775
12
Sarah Jones
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.2.2.3]
b. 23 Sep 1777 d. 17 May 1838 [
=>
]
12
Mary Jones
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.2.2.4]
b. 9 Dec 1780 d. 30 Oct 1831 [
=>
]
12
Lydia Jones
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.2.2.5]
b. 15 Oct 1783
12
Seth Corbett Jones, Jr
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.2.2.6]
b. 16 Oct 1785 d. 27 May 1807
12
Altheda Jones
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.2.2.7]
b. 27 Oct 1787 d. 28 Mar 1790
12
Cynthia Jones
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.2.2.8]
b. 13 May 1791 d. 5 Jan 1827
12
Rachel Jones
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.2.2.9]
b. 23 Apr 1793 d. 3 May 1823
11
David Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.2.3]
b. 27 Jun 1751 d. 14 May 1777
Bulah Johnson
b. 1750
12
Azubah Dagget
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.2.3.1]
b. 15 Mar 1774 [
=>
]
Azubah Wheelock
b. 15 Jan 1745 d. 8 Feb 1804
12
Lyman Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.2.3.2]
b. 22 Aug 1775 d. 30 Apr 1870 [
=>
]
12
David Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.2.3.3]
b. 31 Jan 1776 d. 28 Sep 1861 [
=>
]
11
Hannah Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.2.4]
b. 23 Dec 1753
11
Martha Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.2.5]
b. 2 Jun 1755
Edward Wheelock
b. 1754
12
Relief Wheelock
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.2.5.1]
b. 2 Sep 1777
12
Silas Wheelock
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.2.5.2]
b. 20 Apr 1781 d. 30 Oct 1851 [
=>
]
12
Lynda Wheelock
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.2.5.3]
b. 15 Apr 1783
12
Reuben Wheelock
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.2.5.4]
b. 23 Jul 1785 d. 29 Jul 1833 [
=>
]
11
Aaron Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.2.6]
b. 12 Mar 1757 d. 3 Jun 1759
11
Lidia Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.2.7]
b. 4 Oct 1758 d. 23 Mar 1836
Naham Lamb
b. 13 Jul 1759 d. 22 May 1842
12
Amasa Lamb
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.2.7.1]
b. 24 Jul 1786 d. 12 Jun 1815
12
Linda Lamb
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.2.7.2]
b. 14 Oct 1788
12
Patee Lamb
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.2.7.3]
b. 10 Jan 1791
12
Nahum Lamb
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.2.7.4]
b. 4 Aug 1793
12
Lydia Lamb
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.2.7.5]
b. 3 Feb 1796
12
Jason Lamb
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.2.7.6]
b. 9 Oct 1798 d. 2 Aug 1873 [
=>
]
12
Gerson Lamb
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.2.7.7]
b. 8 Aug 1800 d. 13 Nov 1885 [
=>
]
12
Washington Lamb
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.2.7.8]
b. 6 May 1803
10
William Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.3]
b. 15 Aug 1727 d. 15 Jan 1813
Thankful Gleason
b. 17 Jun 1738 d. 28 Dec 1813
11
Asa Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.3.1]
b. 7 Jul 1760 d. Abt 1830
Waitstill Monroe
b. 2 Jan 1764
12
Asel Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.3.1.1]
b. 16 Aug 1798 d. 6 Jan 1848 [
=>
]
11
Anna Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.3.2]
b. 11 Sep 1762 d. Aft 1788
William Estey
b. 9 Aug 1759 d. 1843
12
Nabby Estey
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.3.2.1]
b. 8 Jul 1791
12
Fanny Estey
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.3.2.2]
b. 28 Mar 1793
12
Betsey Estey
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.3.2.3]
b. 26 Apr 1795
12
Anna Estey
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.3.2.4]
b. 25 Aug 1797
12
Gilman Estey
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.3.2.5]
b. 14 Oct 1799 d. 14 Oct 1877
12
Caroline Estey
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.3.2.6]
b. 27 Dec 1801
11
Phineas Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.3.3]
b. 22 Aug 1764
Betsey Wilson
b. 1769 d. 11 Aug 1791
12
William Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.3.3.1]
b. 21 Dec 1788 d. 2 Jun 1818 [
=>
]
12
Artemas Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.3.3.2]
b. 17 Jul 1790 d. 1835 [
=>
]
Marcy Pierce
b. 6 Aug 1771 d. 29 Jun 1850
12
Polly Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.3.3.3]
b. 6 Aug 1795 d. 6 Aug 1802
12
Hiram Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.3.3.4]
b. 9 Aug 1797 d. 1 Jan 1832
12
Betsey Dagget
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.3.3.5]
b. 31 Dec 1799 d. 1877 [
=>
]
12
Hollis Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.3.3.6]
b. 4 Nov 1802 d. 1882 [
=>
]
12
Lewis Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.3.3.7]
b. 15 Aug 1804 [
=>
]
12
Prentis Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.3.3.8]
b. 25 Aug 1807 d. 29 Oct 1881
12
Mary Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.3.3.9]
b. 1809 d. 1841 [
=>
]
12
Louisa Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.3.3.10]
b. 10 Dec 1812 [
=>
]
11
Nathaniel Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.3.4]
b. 1766 d. 16 Jun 1852
Electa Roberts
b. 12 Dec 1771 d. 27 Oct 1856
12
Harry Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.3.4.1]
b. 1793 d. 14 Nov 1869 [
=>
]
12
Shubael Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.3.4.2]
b. 1797
12
Orville Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.3.4.3]
b. 1799
12
Celista Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.3.4.4]
b. 1801 d. 6 Jan 1862
12
Phineas Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.3.4.5]
b. 1802
12
Phinehas Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.3.4.6]
b. 9 Aug 1802 d. 30 Oct 1877 [
=>
]
12
Nathaniel Daggett, Jr
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.3.4.7]
b. 1804
12
Alpheus Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.3.4.8]
b. 1807
12
Samuel Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.3.4.9]
b. 1810
12
Philarmon Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.3.4.10]
b. 1812
12
Amos Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.3.4.11]
b. 1814
12
Electa Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.3.4.12]
b. 1816
11
Susan Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.3.5]
b. Abt 1768
John Rice
b. 1764 d. 1841
12
Nancy Rice
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.3.5.1]
b. 1789
12
John Rice
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.3.5.2]
b. 1791 d. Aft 1824 [
=>
]
12
Mary "Polly" Rice
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.3.5.3]
b. 1793 d. 1854 [
=>
]
12
Lewis Rice
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.3.5.4]
b. 1796 d. 1835
12
Louisa Rice
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.3.5.5]
b. 1798
12
Fannie Rice
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.3.5.6]
b. 1800 d. Aft 1821 [
=>
]
12
Lucinda Rice
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.3.5.7]
b. 1802
12
Horace Rice
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.3.5.8]
b. 1804
12
Emily Rice
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.3.5.9]
b. 1809
12
Susan Rice
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.3.5.10]
b. 1811
12
George Rice
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.3.5.11]
b. 1807
11
Hannah Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.3.6]
b. 1770
+
Horton
11
Sarah Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.3.7]
b. Abt 1772
11
Amos Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.3.8]
b. Abt 1772
11
Daughter Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.3.9]
b. Abt 1774
+
William Ide
10
Arthur Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.4]
b. 30 Jan 1730 d. 23 Aug 1775
Mehitable King
b. 8 May 1731 d. 13 Mar 1809
11
Arthur Daggett, Jr
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.4.1]
b. 23 Apr 1751 d. 25 Aug 1835
Lucy Cutler
b. 17 Apr 1749 d. 23 Feb 1813
12
Arthur Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.4.1.1]
b. 13 Sep 1774 d. 11 Jan 1855 [
=>
]
12
Stephen Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.4.1.2]
b. 7 Mar 1776 d. 22 Dec 1810 [
=>
]
12
John Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.4.1.3]
b. 22 Dec 1777 d. 26 Aug 1820 [
=>
]
12
Simeon Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.4.1.4]
b. 11 Jun 1779 d. 25 Jan 1823
12
Polly Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.4.1.5]
b. 14 Feb 1781 d. 1 Nov 1813 [
=>
]
12
Cate Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.4.1.6]
b. 4 Apr 1786
12
Lucy Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.4.1.7]
b. 27 Sep 1789
12
Mehitable Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.4.1.8]
b. 1793 d. 14 Aug 1844
11
Mehetabel Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.4.2]
b. 10 Oct 1752 d. 20 Apr 1834
Jonathon Rich
b. 20 Jul 1747 d. 28 Aug 1828
12
Reuben Rich
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.4.2.1]
b. 26 Apr 1775
12
Simeon Rich
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.4.2.2]
b. 6 Mar 1780 d. 11 Sep 1855 [
=>
]
12
Arthur Rich
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.4.2.3]
b. 13 Oct 1777
12
Cynthia Rich
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.4.2.4]
b. Abt 1779
12
Jonathan Rich, Jr
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.4.2.5]
b. 19 Nov 1782
12
Paul Rich
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.4.2.6]
b. 16 Aug 1785
12
Barnabas Rich
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.4.2.7]
b. 13 Oct 1787
11
Simeon Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.4.3]
b. 7 Mar 1757 d. 9 May 1819
Anna Dean
b. 1759 d. 9 May 1819
12
Nancy Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.4.3.1]
b. Abt 1779
12
Simeon Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.4.3.2]
b. 1780 d. 17 Jun 1854 [
=>
]
12
Sally Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.4.3.3]
b. 1782
12
Son Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.4.3.4]
b. Abt 1784
12
Nathaniel Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.4.3.5]
b. 12 Jul 1785 d. Abt 1827 [
=>
]
12
Caleb C Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.4.3.6]
b. Abt 1790 d. 23 Dec 1879
12
Artemas Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.4.3.7]
b. 17 Jul 1790
12
Mary Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.4.3.8]
b. 10 Nov 1795 d. 18 Aug 1864 [
=>
]
11
Gideon Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.4.4]
b. 21 Dec 1759 d. 27 Aug 1838
Elizabeth Pratt
b. 22 Jul 1759 d. 1822
12
Gardner Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.4.4.1]
b. 12 Oct 1788 d. Oct 1843 [
=>
]
12
William King Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.4.4.2]
b. 24 Aug 1792 d. 6 Feb 1862
12
Nancy Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.4.4.3]
b. 1793
12
Harvey Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.4.4.4]
b. 1797
12
Gideon Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.4.4.5]
b. 1800
11
Betty Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.4.5]
b. 3 Feb 1763 d. 28 Jul 1829
Thomas Todd
b. 17 Nov 1760 d. 20 Nov 1848
12
Billy Todd
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.4.5.1]
b. 15 Jul 1783 d. 1871
12
Lavina Todd
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.4.5.2]
b. 1 Sep 1785 d. Mar 1835
12
Orinda Todd
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.4.5.3]
b. 1 Sep 1787 d. 12 Jun 1872 [
=>
]
12
Diantha Todd
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.4.5.4]
b. 1 May 1791 d. 27 Dec 1824
12
Elmer Todd
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.4.5.5]
b. 16 Jun 1793 d. 13 Oct 1812
12
Relief Todd
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.4.5.6]
b. 11 Mar 1798 d. 19 Oct 1885 [
=>
]
12
Alanson Todd
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.4.5.7]
b. 5 Sep 1800 d. 13 Jul 1882 [
=>
]
12
Charles Todd
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.4.5.8]
b. 27 Sep 1802 d. 8 Apr 1804
12
Hiram Todd
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.4.5.9]
b. 18 Nov 1795 d. 11 Jul 1849 [
=>
]
12
Solomon Todd
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.4.5.10]
b. 15 Oct 1804 d. 17 Oct 1832
12
Betsey Todd
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.4.5.11]
b. 8 Nov 1806 [
=>
]
11
Tamar Daggett
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.4.6]
b. 24 Mar 1767 d. 23 Oct 1820
Eliphalet Holman
b. Abt 1761 d. 30 May 1838
12
Catharine Holman
[1.1.1.2.3.1.1.1.4.4.6.1]
b. 3 Dec 1789 d. 11 Aug 1864 [
=>
]
9
Samuel Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.5]
b. 16 May 1697 d. Dec 1730
Martha Dike
b. Abt 1700 d. 5 Oct 1775
10
Samuel Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.5.1]
b. 1724 d. 31 Aug 1801
10
Nathaniel Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.5.2]
b. Abt 1725 d. 24 May 1811
Ruth Bradish
b. 7 May 1722 d. 12 Aug 1810
11
Ruth Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.5.2.1]
b. 9 Apr 1745 d. 30 Nov 1814
Benoni Benson
b. 11 Jul 1747 d. 1803
12
John Benson
[1.1.1.2.3.1.1.1.5.2.1.1]
b. 1789
11
Martha Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.5.2.2]
b. 17 Apr 1747 d. 4 Mar 1775
11
Mary Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.5.2.3]
b. 1 Sep 1749
11
Eunice Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.5.2.4]
b. 27 Feb 1752 d. Mar 1775
11
Nathan Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.5.2.5]
b. 22 Jun 1754 d. 22 Feb 1755
11
Stephen Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.5.2.6]
b. 21 Sep 1756
11
Nathaniel Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.5.2.7]
b. 20 Apr 1759 d. 25 Aug 1775
11
Jonas Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.5.2.8]
b. 7 Mar 1762 d. 5 Feb 1834
10
Lucy Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.5.3]
b. 16 Apr 1726 d. 13 Dec 1821
10
Jeremiah Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.5.4]
b. 31 Dec 1728 d. Abt 1807
10
Benjamin Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.5.5]
b. 27 Feb 1731 d. Aft 27 Jan 1794
9
William Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.6]
c. 7 Sep 1700 d. 18 Sep 1763
Sarah
b. Abt 1703
10
William Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.6.1]
b. 4 May 1727
10
Elijah Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.6.2]
b. Abt 1728
10
Sarah Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.6.3]
b. 23 Aug 1730 d. 13 Jun 1816
10
Daniel Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.6.4]
b. 31 Jan 1732
10
David Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.6.5]
b. 3 Oct 1736
9
Benjamin Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.7]
b. 19 Sep 1703 d. 2 Nov 1780
Pricilla Rich
b. 28 Sep 1706 d. 1 Feb 1782
10
Priscilla Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.7.1]
b. 5 Aug 1725 d. 6 Feb 1737
10
Benjamin Sibley, Jr
[1.1.1.2.3.1.1.1.7.2]
b. 17 Aug 1727 d. 12 Nov 1789
10
Zuruiah Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.7.3]
b. 31 Aug 1729 d. Aft 1770
10
Susanna Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.7.4]
b. 31 Aug 1733 d. 24 Apr 1810
10
Ezra Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.7.5]
b. 4 Aug 1738 d. 11 Oct 1762
10
Aaron Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.7.6]
b. 2 Jul 1740 d. 1776
10
Moses Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.7.7]
b. 9 May 1743 d. 16 Sep 1760
10
Joseph Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.7.8]
b. 19 Aug 1745
10
Samuel Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.7.9]
b. 14 Jun 1747 d. 1841
10
Jonathan Sibley
[1.1.1.2.3.1.1.1.7.10]
b. 4 Mar 1750 d. 31 Jul 1828
7
Elizabeth Black
[1.1.1.2.3.1.2]
b. Abt 1632
Sir Humphrey Gilbert
b. 1616 d. Bef 30 Mar 1658
8
Martha Gilbert
[1.1.1.2.3.1.2.1]
b. Abt 1651 d. Bef 4 Feb 1692
8
Abigail Gilbert
[1.1.1.2.3.1.2.2]
b. Abt 1654 d. 1735
8
Esther Gilbert
[1.1.1.2.3.1.2.3]
b. 1654
8
John Gilbert
[1.1.1.2.3.1.2.4]
b. 1656 d. 17 Mar 1722
Elizabeth Kilham
b. 1657 d. 17 Mar 1722
9
Mary Gilbert
[1.1.1.2.3.1.2.4.1]
b. Abt 1681 d. 1681
9
Elizabeth Gilbert
[1.1.1.2.3.1.2.4.2]
b. Abt 1683
9
Daniel Gilbert
[1.1.1.2.3.1.2.4.3]
b. Abt 1685 d. 2 Nov 1723
Elisabeth Porter
b. Abt 1689 d. Jan 1789
10
Lydia Gilbert
[1.1.1.2.3.1.2.4.3.1]
b. 9 Dec 1711 d. Abt 1757
10
Mary Gilbert
[1.1.1.2.3.1.2.4.3.2]
b. 17 Sep 1721 d. 1760
10
Elizabeth Gilbert
[1.1.1.2.3.1.2.4.3.3]
c. 13 Nov 1713 d. 21 Aug 1751
Joseph Noyes
b. 14 Jul 1710 d. 1754
11
Elizabeth Noyes
[1.1.1.2.3.1.2.4.3.3.1]
b. 18 Dec 1735 d. 9 Jul 1829
Thomas Phillips
b. 7 Jun 1747 d. 9 Jul 1829
12
Rhoda Phillips
[1.1.1.2.3.1.2.4.3.3.1.1]
b. Abt 1770 d. 23 Nov 1825 [
=>
]
12
Mary Phillips
[1.1.1.2.3.1.2.4.3.3.1.2]
b. 1 Oct 1774 d. 20 Apr 1844
12
Rachael Phillips
[1.1.1.2.3.1.2.4.3.3.1.3]
b. 1777 d. 9 Mar 1864
12
Russel Phillips
[1.1.1.2.3.1.2.4.3.3.1.4]
b. 31 Aug 1785 d. 15 Apr 1856
12
Caleb Phillips
[1.1.1.2.3.1.2.4.3.3.1.5]
b. Abt 1787
12
Moses Phillips
[1.1.1.2.3.1.2.4.3.3.1.6]
b. Abt 1789
12
Betsey Phillips
[1.1.1.2.3.1.2.4.3.3.1.7]
b. 1789 d. 1813
12
Dorcas Phillips
[1.1.1.2.3.1.2.4.3.3.1.8]
b. Abt 1789
11
Mary Noyes
[1.1.1.2.3.1.2.4.3.3.2]
b. 28 Dec 1737
11
Daniel Noyes
[1.1.1.2.3.1.2.4.3.3.3]
b. 10 Jun 1740 d. Abt 1824
11
Moses Noyes
[1.1.1.2.3.1.2.4.3.3.4]
b. 11 May 1743
10
Mercy Gilbert
[1.1.1.2.3.1.2.4.3.4]
c. 1 Apr 1716
10
Daniel Gilbert
[1.1.1.2.3.1.2.4.3.5]
c. 13 Apr 1718
10
Hannah Gilbert
[1.1.1.2.3.1.2.4.3.6]
c. 23 Dec 1722
9
Martha Gilbert
[1.1.1.2.3.1.2.4.4]
b. Abt 1688
9
Benjamin Gilbert
[1.1.1.2.3.1.2.4.5]
b. 1 Feb 1691 d. 24 Jun 1760
9
Joseph Gilbert
[1.1.1.2.3.1.2.4.6]
b. 1 Feb 1691 d. Mar 1763
9
Noah Gilbert
[1.1.1.2.3.1.2.4.7]
b. 21 Nov 1703 d. 22 Nov 1768
7
Lydia Black
[1.1.1.2.3.1.3]
b. 25 Dec 1636
7
Lydia Black
[1.1.1.2.3.1.4]
b. 3 Jun 1638 d. Bef 1748
7
John Black, Jr
[1.1.1.2.3.1.5]
b. 1642 d. 18 Aug 1700
6
Patrick Black
[1.1.1.2.3.2]
b. 28 Sep 1692
4
Gilbert Skene
[1.1.1.3]
b. Abt 1538 d. 1604
4
William Skene
[1.1.1.4]
b. Abt 1539 d. 29 Aug 1635
4
Patrick Skene
[1.1.1.5]
b. Abt 1540 d. 29 Aug 1635
4
Alexander Skene
[1.1.1.6]
b. Abt 1541 d. 1601
2
James de Skeen
[1.2]
b. Abt 1500 d. 1547