Home Page
|
What's New
|
Photos
|
Histories
|
Headstones
|
Reports
|
Surnames
Search
First Name:
Last Name:
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
English
Dansk
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlands
Suomalainen
Svenska
Henry Drake
1574 - 1623 (49 years)
Submit Photo / Document
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Submit Photo / Doc
Worksheet
Family
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Henry Drake
[1]
b. 1574 d. 6 Apr 1623
Mary Parker
b. Abt 1572 d. 1596
2
Mathew Drake
[1.1]
b. Abt 1590 d. 1653
2
Edmond Drake
[1.2]
b. 30 Nov 1592
2
Katherine Drake
[1.3]
b. Abt 1594
2
Joanna Drake
[1.4]
b. 1596 d. 11 Apr 1659
Henry Kingman
b. 1595 d. 4 May 1677
3
Edward Kingman
[1.4.1]
b. Abt 1619
3
Joanna Kingman
[1.4.2]
b. 1624 d. 1696
Thomas Holbrook
b. 1624 d. 22 Jul 1697
4
John Holbrook
[1.4.2.1]
b. 15 Oct 1653 d. 25 Dec 1678
4
Peter Holbrook
[1.4.2.2]
b. 6 Sep 1656 d. 3 May 1712
Alice Godfrey
b. 1656 d. 29 Apr 1705
5
John Holbrook
[1.4.2.2.1]
b. 24 Sep 1679 d. 11 May 1765
5
Peter Holbrook
[1.4.2.2.2]
b. 16 Oct 1681 d. 24 Dec 1738
5
Joseph Holbrook
[1.4.2.2.3]
b. 8 May 1683 d. 25 Apr 1750
5
Sylvanus Holbrook
[1.4.2.2.4]
b. 15 Aug 1685 d. 1740
Naomi Cook
b. 13 Mar 1693 d. Bef 14 Jun 1762
6
Ruth Holbrook
[1.4.2.2.4.1]
b. 13 May 1713
6
Sylvanus Holbrook
[1.4.2.2.4.2]
b. 13 May 1713 d. 1782
Thankful Thayer
b. 4 Aug 1725 d. 10 Dec 1798
7
Sylvanus Holbrook
[1.4.2.2.4.2.1]
b. 21 Apr 1750 d. 1828
Mary Thayer
b. 7 Jun 1749 d. 26 May 1831
8
Phebe Holbrook
[1.4.2.2.4.2.1.1]
b. 16 Feb 1773 d. 25 Oct 1832
8
Ezekiel Holbrook
[1.4.2.2.4.2.1.2]
b. 18 Apr 1777 d. 1799
8
Joseph Holbrook
[1.4.2.2.4.2.1.3]
b. 6 Nov 1781
8
Polly Holbrook
[1.4.2.2.4.2.1.4]
b. 1783
8
Mary Holbrook
[1.4.2.2.4.2.1.5]
b. 16 Oct 1784 d. 15 Aug 1844
7
Ruth Holbrook
[1.4.2.2.4.2.2]
b. 10 Aug 1751 d. 16 May 1781
Benoni Benson
b. 11 Jul 1747 d. 1803
8
Amasa Benson
[1.4.2.2.4.2.2.1]
b. 25 Jan 1771 d. 7 Mar 1837
Levina Turtilot
b. 20 Feb 1777 d. 1 May 1865
9
Henry Holbrook Benson
[1.4.2.2.4.2.2.1.1]
b. 22 Mar 1801
Almira A
b. 26 Aug 1817
10
Leander A Benson
[1.4.2.2.4.2.2.1.1.1]
b. 1838 d. 10 Aug 1839
10
Henry A Benson
[1.4.2.2.4.2.2.1.1.2]
b. 23 Feb 1843 d. 19 Aug 1844
10
Seth Hall Benson
[1.4.2.2.4.2.2.1.1.3]
b. 6 Jul 1847 d. 1915
10
Edwin Benson
[1.4.2.2.4.2.2.1.1.4]
b. Abt 1851
9
James Davis Benson
[1.4.2.2.4.2.2.1.2]
b. 15 Nov 1802 d. 5 Sep 1805
9
Chloe Benson
[1.4.2.2.4.2.2.1.3]
b. 2 Oct 1804 d. 28 Mar 1844
Horace B Robbins
b. 28 Mar 1797 d. 24 Feb 1879
10
Alvin Cook Robbins
[1.4.2.2.4.2.2.1.3.1]
b. 12 May 1828
Mary L W Meggett
b. 1830
11
Mary E Robbins
[1.4.2.2.4.2.2.1.3.1.1]
b. Abt 1857
11
Arthur M Robbins
[1.4.2.2.4.2.2.1.3.1.2]
b. Abt 1858
11
Jennie T Robbins
[1.4.2.2.4.2.2.1.3.1.3]
b. Sep 1860
+
Charles L Browning
b. Jun 1840 d. 24 Oct 1903
11
Annette C Robbins
[1.4.2.2.4.2.2.1.3.1.4]
b. Abt 1863
11
Wallace A Robbins
[1.4.2.2.4.2.2.1.3.1.5]
b. Dec 1869
10
Ann Mariah Robbins
[1.4.2.2.4.2.2.1.3.2]
b. 6 Jul 1830
10
Henry Davis Robbins
[1.4.2.2.4.2.2.1.3.3]
b. 22 Sep 1834
10
Charles W Robbins
[1.4.2.2.4.2.2.1.3.4]
b. Abt 1837
10
Sanford Augustus Robbins
[1.4.2.2.4.2.2.1.3.5]
b. 9 May 1840
9
Maria R Benson
[1.4.2.2.4.2.2.1.4]
b. 17 Dec 1806
Alvin Cook
b. 1805 d. 9 Jun 1872
10
Ellen L Cook
[1.4.2.2.4.2.2.1.4.1]
b. 1830
10
Miriam A Cook
[1.4.2.2.4.2.2.1.4.2]
b. Oct 1834 d. 24 Mar 1835
10
Aaron Cook
[1.4.2.2.4.2.2.1.4.3]
b. 26 Jun 1837
10
Samantha Maria Cook
[1.4.2.2.4.2.2.1.4.4]
b. Abt 1841
Caleb Edmund Thayer
b. 3 Sep 1841 d. 27 Aug 1868
11
Florence Thayer
[1.4.2.2.4.2.2.1.4.4.1]
b. Apr 1868
10
Alice Salina Cook
[1.4.2.2.4.2.2.1.4.5]
b. 26 Feb 1844
10
Winfield E Cook
[1.4.2.2.4.2.2.1.4.6]
b. 21 Jun 1847
10
Ellen Louisa Cooke
[1.4.2.2.4.2.2.1.4.7]
c. 3 Sep 1843
9
Charles Holbrook Benson
[1.4.2.2.4.2.2.1.5]
b. 14 Sep 1809
+
Adaline M Hayward
b. 22 Feb 1823
9
Angeline Benson
[1.4.2.2.4.2.2.1.6]
b. 20 Jul 1811
9
Ann Eliza Benson
[1.4.2.2.4.2.2.1.7]
b. 20 Feb 1813
9
Elsa T Benson
[1.4.2.2.4.2.2.1.8]
b. 17 Jul 1815
9
Nathan Benson
[1.4.2.2.4.2.2.1.9]
b. 30 Nov 1817
9
William Hall Benson
[1.4.2.2.4.2.2.1.10]
b. 24 Oct 1819
8
Chloe Benson
[1.4.2.2.4.2.2.2]
b. 28 Jan 1774
8
Benoni Benson
[1.4.2.2.4.2.2.3]
b. 1780 d. 1819
7
Rachel Holbrook
[1.4.2.2.4.2.3]
b. 6 Nov 1753 d. 9 Mar 1832
Jonathan Staples
b. 29 Mar 1754 d. 28 Nov 1832
8
Sally Staples
[1.4.2.2.4.2.3.1]
b. 3 Oct 1779
8
Sylvia Staples
[1.4.2.2.4.2.3.2]
b. 2 Jan 1781 d. 13 Mar 1852
8
Rachael Staples
[1.4.2.2.4.2.3.3]
b. Abt 1784 d. 12 Dec 1870
8
Ellery Staples
[1.4.2.2.4.2.3.4]
b. 1784 d. 1861
8
Willard Staples
[1.4.2.2.4.2.3.5]
b. 20 Dec 1785 d. 20 Dec 1858
8
Jonathan Staples
[1.4.2.2.4.2.3.6]
b. 1792
7
Comfort Holbrook
[1.4.2.2.4.2.4]
b. 12 Mar 1756
7
Margaret Holbrook
[1.4.2.2.4.2.5]
b. 14 Aug 1757 d. Abt 1805
Thadaus Thayer
b. 1 Feb 1754 d. 24 Dec 1826
8
George Thayer
[1.4.2.2.4.2.5.1]
b. 20 Jul 1779 d. 27 May 1836
8
Otis Thayer
[1.4.2.2.4.2.5.2]
b. 17 Mar 1780 d. 13 Apr 1841
8
Arkey Thayer
[1.4.2.2.4.2.5.3]
b. 6 Dec 1781 d. 1783
8
Ellis Holbrook Thayer
[1.4.2.2.4.2.5.4]
b. 9 Mar 1783 d. 2 Jul 1863
8
Ruth Thayer
[1.4.2.2.4.2.5.5]
b. Abt 1784 d. 1821
8
Sylvanus Thayer
[1.4.2.2.4.2.5.6]
b. Abt 1786 d. 7 Mar 1859
8
Margaret Thayer
[1.4.2.2.4.2.5.7]
b. 11 Nov 1787
8
Thaddeus Thayer
[1.4.2.2.4.2.5.8]
b. Nov 1789 d. 4 Mar 1824
8
Margery Thayer
[1.4.2.2.4.2.5.9]
b. 2 May 1792
8
Maranda Thayer
[1.4.2.2.4.2.5.10]
b. Abt 1794
8
Barbara Thayer
[1.4.2.2.4.2.5.11]
b. 25 Jun 1797 d. 1822
8
Diana Thayer
[1.4.2.2.4.2.5.12]
b. 6 Jan 1800 d. 17 Nov 1861
7
Thankful Holbrook
[1.4.2.2.4.2.6]
b. 23 Feb 1760 d. 25 May 1834
David Legg
b. 11 May 1756 d. 25 Apr 1844
8
Thankful Holbrook Legg
[1.4.2.2.4.2.6.1]
b. Abt 1803
7
Mary Holbrook
[1.4.2.2.4.2.7]
b. 1 Feb 1762 d. 27 Dec 1814
John Benson
b. 1 Aug 1749 d. 18 May 1818
8
John Perry Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1]
b. 22 Jul 1781 d. 21 Jan 1842
Chloe Taft
b. 7 Jul 1785 d. 25 Apr 1826
9
Charlotte Taft Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.1]
b. 30 Sep 1807 d. 16 Jul 1878
Moses Dyer
b. 1803 d. Aft 1841
10
Merril B Dyer
[1.4.2.2.4.2.7.1.1.1]
b. 2 Apr 1844 d. 2 Apr 1859
10
George Franklin Dyer
[1.4.2.2.4.2.7.1.1.2]
b. 22 Jan 1846 d. 27 Feb 1917
Ellen Jane Hubbard
b. 1848 d. 1925
11
Merrill Eugene Dyer
[1.4.2.2.4.2.7.1.1.2.1]
b. 18 Dec 1869 d. 1926
Lena Hartshorn
b. 1872
12
Hazel Dyer
[1.4.2.2.4.2.7.1.1.2.1.1]
b. 5 Sep 1899 d. 24 Oct 1984
12
Leo Carlton Dyer
[1.4.2.2.4.2.7.1.1.2.1.2]
b. 22 Jan 1902 d. 18 Jul 1910
12
Clara Dyer
[1.4.2.2.4.2.7.1.1.2.1.3]
b. 15 Dec 1902 d. 24 Jul 1998
10
Chloe Allice Dyer
[1.4.2.2.4.2.7.1.1.3]
b. 5 May 1848 d. 1932
Sanford Brown
b. 10 Feb 1844 d. 1883
11
Charlotta B Brown
[1.4.2.2.4.2.7.1.1.3.1]
b. 22 Feb 1871
+
Clements Roehrig
b. 1869
11
Paul Brown
[1.4.2.2.4.2.7.1.1.3.2]
b. 12 Jan 1873 d. 24 Nov 1952
Beatrice Hart
b. 1872
12
Ruth Brown
[1.4.2.2.4.2.7.1.1.3.2.1]
b. 18 Aug 1899
11
Sanford Brown
[1.4.2.2.4.2.7.1.1.3.3]
b. 17 Mar 1876 d. 5 Sep 1905
+
Clara Marie Perry
b. Dec 1875
11
Elizabeth Brown
[1.4.2.2.4.2.7.1.1.3.4]
b. 25 May 1879
+
Alfred E Truman
b. 1877
11
Neil Brown
[1.4.2.2.4.2.7.1.1.3.5]
b. 25 Mar 1882 d. 5 Nov 1913
10
Angelne A Dyer
[1.4.2.2.4.2.7.1.1.4]
b. 6 Sep 1852
Orison J Batchelor
b. 11 Jul 1851 d. 10 Jan 1913
11
Chloe Edith Bachelor
[1.4.2.2.4.2.7.1.1.4.1]
b. 11 Sep 1873
11
Nina F Bachelor
[1.4.2.2.4.2.7.1.1.4.2]
b. 30 Nov 1875
11
Maria Frances Bachelor
[1.4.2.2.4.2.7.1.1.4.3]
b. 30 Nov 1875
9
Ezra Taft Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2]
b. 22 Feb 1811 d. 3 Sep 1869
Pamelia Andrus
b. 21 Oct 1809 d. 14 Sep 1877
10
Charles Agustus Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.1]
b. 26 Sep 1832 d. 14 Oct 1833
10
Chloe Jane Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.2]
b. 1835 d. 1835
10
Charles Augustus Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.3]
b. 9 Jul 1837 d. 18 Feb 1873
10
Jonathan Parsons Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.4]
b. Mar 1841 d. Mar 1841
10
Adin Parsons Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.5]
b. Mar 1841 d. Mar 1841
10
Pamelia Emma Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.6]
b. 28 Feb 1842 d. 10 Feb 1892
10
Harvey Andrus Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.7]
b. 26 Sep 1844 d. 26 Sep 1844
10
Isabella Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.8]
b. 9 Mar 1846 d. 10 Feb 1922
10
Charlotte Taft Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.9]
b. 4 Jul 1850 d. 30 Nov 1918
Winfield Scott Norcross
b. 16 Jul 1844 d. 7 Jan 1915
11
Irving Norcross
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.9.1]
b. 1880
11
Winfield Irvin Norcross
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.9.2]
b. 18 Jun 1884
Adeline Brooks Andrus
b. 18 Mar 1813 d. 20 Apr 1898
10
George Taft Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10]
b. 1 May 1846 d. 16 May 1919
Louisa Alexandrine Ballif
b. 25 Feb 1850 d. 7 Feb 1922
11
Louisa "Lulu" Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.1]
b. 28 Mar 1869 d. 15 Jul 1938
William Chandler Parkinson
b. 2 Aug 1855 d. 18 Nov 1929
12
Louisa Benson Parkinson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.1.1]
b. 5 Jul 1889 d. 12 Sep 1973 [
=>
]
12
Marie Benson Parkinson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.1.2]
b. 13 Dec 1891 d. 22 Jan 1919
12
Charlotte Benson Parkinson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.1.3]
b. 16 Jul 1894 d. 13 Oct 1980
12
Clara Parkinson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.1.4]
b. 8 Aug 1897 d. 6 Oct 1992 [
=>
]
12
George Benson Parkinson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.1.5]
b. 17 Oct 1899 d. 31 Oct 1918
12
Adeline Parkinson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.1.6]
b. 2 Jan 1902 d. 27 Apr 1990 [
=>
]
12
Wilbur Chandler Parkinson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.1.7]
b. 10 Oct 1904 d. 20 Dec 1988 [
=>
]
12
Carmen Parkinson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.1.8]
b. 5 Oct 1907 d. 24 Mar 1993 [
=>
]
12
Evelyn Parkinson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.1.9]
b. 30 Mar 1910 d. 30 Jun 1991
12
Wanda Parkinson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.1.10]
b. 31 Jul 1911 d. 13 Jun 1995 [
=>
]
11
Ezra Taft Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.2]
b. 6 Aug 1871 d. 28 Aug 1871
11
Elise Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.3]
b. 10 Mar 1873 d. 22 Aug 1937
George Alfred Alder, Jr
b. 4 Jan 1874 d. 3 May 1940
12
Ione Benson Alder
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.3.1]
b. 9 Jul 1896 d. 6 Oct 1983 [
=>
]
12
Lydia Dunford Alder
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.3.2]
b. 30 Nov 1898 d. 7 Aug 1983
12
Linden Benson Alder
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.3.3]
b. 20 Mar 1900 d. 8 Aug 1957 [
=>
]
12
Garold Benson Alder
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.3.4]
b. 2 May 1902 d. 12 Jun 1960 [
=>
]
12
George Benson Alder
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.3.5]
b. 1 May 1906 d. 11 Nov 1974 [
=>
]
12
Ballif Benson Alder
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.3.6]
b. 1 May 1906 d. 23 Nov 1906
12
Donald Benson Alder
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.3.7]
b. 4 Dec 1908 d. 14 Mar 1993 [
=>
]
12
George Alfred Alder
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.3.8]
b. 9 Jul 1912 d. 29 Mar 1913
11
George Taft Benson, Jr
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.4]
b. 24 Jun 1875 d. 13 Aug 1934
Sarah Sophia Dunkley
b. 29 Jun 1878 d. 1 Jun 1933
12
Ezra Taft Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.4.1]
b. 4 Aug 1899 d. 30 May 1994 [
=>
]
12
Joseph Dunkley Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.4.2]
b. 12 Nov 1900 d. 24 Apr 1936 [
=>
]
12
Margaret Dunkley Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.4.3]
b. 16 Feb 1902 d. 3 Jul 1999 [
=>
]
12
Orval Dunkley Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.4.4]
b. 30 Aug 1903 d. 1 Jul 1991 [
=>
]
12
Louisa Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.4.5]
b. 10 Oct 1905 d. 2 Jul 1996 [
=>
]
12
Lera Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.4.6]
b. 4 May 1907 d. 10 Jun 2009 [
=>
]
12
Valdo Dunkley Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.4.7]
b. 23 Apr 1911 d. 30 Oct 1990 [
=>
]
12
George Taft Benson, III
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.4.8]
b. 27 Aug 1912 d. 15 Apr 1990 [
=>
]
12
Sarah Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.4.9]
b. 30 Sep 1914 d. 26 Sep 2001 [
=>
]
12
Ross Dean Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.4.10]
b. 20 Jan 1917 d. 23 Oct 1985
12
Volco Ballif Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.4.11]
b. 11 Apr 1920 d. 13 Mar 1992
+
Clara Maria Danielsen
b. 10 Feb 1892 d. 20 Oct 1958
11
Serge Ballif Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.5]
b. 2 Oct 1877 d. 18 Jan 1959
Melinda Caroline Nelson
b. 8 Sep 1881 d. 27 Jun 1971
12
Sergene Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.5.1]
b. 7 Aug 1904 d. 23 Jun 1995 [
=>
]
12
Serge Nelson Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.5.2]
b. 15 Mar 1906 d. 28 Oct 1994 [
=>
]
12
Constance Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.5.3]
b. 24 Apr 1908 d. 23 Jul 1981 [
=>
]
12
Donna Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.5.4]
b. 16 Mar 1910 d. 5 Dec 1997 [
=>
]
12
Fae Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.5.5]
b. 14 Feb 1914 d. 9 Oct 1968
12
Zetta Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.5.6]
b. 20 Aug 1916 d. 6 Sep 2013 [
=>
]
12
Theodore Nelson Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.5.7]
b. 1 Apr 1919 d. 27 Jan 2006 [
=>
]
12
Jacqueline Maurie Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.5.8]
b. 17 May 1925 d. 23 Apr 2019
11
Adeline Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.6]
b. 31 Jul 1879 d. 27 Jan 1960
Leo Peck
b. 28 Jun 1875 d. 12 Oct 1967
12
Florence Peck
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.6.1]
b. 1 May 1901 d. 23 Apr 1991 [
=>
]
12
Effie Peck
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.6.2]
b. 8 Feb 1903 d. 21 Jul 1992 [
=>
]
12
Leo Benson Peck
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.6.3]
b. 20 Jul 1905 d. 18 Nov 1917
12
Maurine Peck
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.6.4]
b. 22 Nov 1907 d. 4 Aug 1935 [
=>
]
12
Beth Peck
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.6.5]
b. 24 Sep 1912 d. 8 Sep 2000
12
Garth Benson Peck
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.6.6]
b. 18 Apr 1916 d. 14 Dec 1993
12
Olive Louise Peck
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.6.7]
b. 22 Jun 1920 d. 24 Aug 1993 [
=>
]
11
Florence Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.7]
b. 31 Jul 1879 d. 5 Nov 1967
Stanley Detlef Jonasson
b. 4 Mar 1878 d. 8 May 1959
12
Adeline Jonasson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.7.1]
b. 5 Nov 1906 d. 23 Jul 1975
12
Stanley Taft Jonasson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.7.2]
b. 29 Aug 1908 d. 9 Dec 1986
12
Helen Jonasson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.7.3]
b. 27 Sep 1910 d. 17 Oct 1931
12
Dorothy Jonasson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.7.4]
b. 1912 d. 1912
12
Alfred Benson ( Bill ) Jonasson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.7.5]
b. 26 Feb 1919 d. 16 Dec 2000
11
William Kennedy Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.8]
b. 9 Feb 1882 d. 28 Feb 1882
11
Frank Taft Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.9]
b. 23 Apr 1883 d. 19 Feb 1923
Elizabeth Greaves "Lillie" Eames
b. 6 Jun 1884 d. 28 Dec 1966
12
Gladys Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.9.1]
b. 12 Nov 1909 d. 27 Jan 1995 [
=>
]
12
Carmen Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.9.2]
b. 4 Nov 1911 d. 17 Aug 2001 [
=>
]
12
Harold Eames Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.9.3]
b. 4 Nov 1911 d. 20 Jul 1948 [
=>
]
12
Flora Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.9.4]
b. 30 Jan 1916 d. 14 Oct 1984 [
=>
]
12
Zenda Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.9.5]
b. 25 Oct 1918 d. 27 Feb 2003 [
=>
]
12
Frank Eames Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.9.6]
b. 26 Sep 1920 d. 2 Jan 1923
12
Nellie Louisa Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.9.7]
b. 11 Sep 1923 d. 11 Oct 1975 [
=>
]
11
Marie Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.10]
b. 19 Jul 1885 d. 6 Mar 1891
11
Carmen Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.11]
b. 7 Nov 1887 d. 5 Jul 1974
Franklin Brenneman Smith, Jr
b. Abt 1860 d. 11 Apr 1954
12
Franklin Breneman Smith, III
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.11.1]
b. 11 Jun 1923 d. 3 Apr 2009
12
Richard Benson Smith
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.11.2]
b. 15 Jun 1925 d. 8 Dec 2009
11
Jenny Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.12]
b. 30 Jun 1890 d. 12 Jul 1970
Earl Weaver
b. 22 Jun 1890 d. 11 Oct 1977
12
Kinnie Weaver
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.12.1]
b. 30 May 1916 d. 27 Aug 1999
12
Virginia Weaver
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.12.2]
b. 23 Dec 1917 d. 2012 [
=>
]
12
Mary Louise "Louie" Weaver
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.12.3]
b. 15 Jun 1921 d. 16 May 2012 [
=>
]
12
Earl Benson Weaver
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.12.4]
b. 27 Oct 1926 d. 1 Jan 2015 [
=>
]
12
Jenalee Weaver
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.12.5]
b. 1929 d. Aug 2015
11
Kathinka "Kinnie" Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.13]
b. 15 Mar 1894 d. 20 May 1960
Robert Sweeten Holbrook
b. 14 Oct 1893 d. 2 Jun 1980
12
Robert Benson Holbrook
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.13.1]
b. 5 Aug 1917 d. 29 Feb 2000 [
=>
]
12
George Benson Holbrook
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.13.2]
b. 3 Nov 1919 d. 7 Nov 2009 [
=>
]
12
Louise Holbrook
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.13.3]
b. 4 Jun 1912 d. 27 May 2009 [
=>
]
12
Donald Benson Holbrook
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.13.4]
b. 4 Feb 1925 d. 1 Mar 2005 [
=>
]
12
Gordon Benson Holbrook
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.10.13.5]
b. 22 Dec 1926 d. 2 Nov 1993 [
=>
]
10
Florence Adeline Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.11]
b. 17 Sep 1851 d. 25 Dec 1852
10
Nellie Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.12]
b. 30 Nov 1851 d. 24 Jan 1885
10
Frank Andrus Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.13]
b. 16 Oct 1853 d. 5 May 1937
Amanda Charlotta Eliason
b. 4 Jun 1861 d. 12 Mar 1922
11
Eva A Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.13.1]
b. 6 Jul 1882 d. 10 Aug 1946
11
Blanche Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.13.2]
b. 7 May 1888 d. 12 Sep 1979
11
Edna Mae Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.13.3]
b. 19 Oct 1890 d. 19 Mar 1976
11
Frank Andrus Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.13.4]
b. 30 Apr 1895 d. 18 Dec 1968
11
Eleanora Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.13.5]
b. 30 Nov 1896 d. 2 Oct 1992
11
Karl Eliason Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.13.6]
b. 21 Apr 1899 d. 21 Oct 1980
11
Adeline Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.13.7]
b. 14 Mar 1904 d. 5 May 1904
11
George Taft Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.13.8]
b. 17 Aug 1905 d. 18 Feb 1942
10
Samuel Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.14]
b. 1853
Eliza Ann Perry
b. 30 Mar 1828 d. 30 Apr 1913
10
Alice Eliza Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.15]
b. 11 Aug 1848 d. 3 Jun 1923
10
John Perry Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.16]
b. 24 Sep 1849 d. 4 Jan 1921
10
Malina Adelaide Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.17]
b. 21 Sep 1851 d. 31 Jul 1918
10
Orrin William Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.18]
b. 4 Oct 1853 d. 17 May 1917
10
Carrie Stella Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.19]
b. 22 May 1860 d. 15 Mar 1928
10
Abbie Della Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.20]
b. 16 Oct 1862 d. 22 Oct 1925
10
Grace Ann Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.21]
b. 31 Jan 1867 d. 15 Dec 1924
Elizabeth Gollaher
b. 30 Dec 1831 d. 4 May 1904
10
Fredrick Gollaher Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.22]
b. 17 Jan 1855 d. 6 Jan 1915
10
Brigham Young Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.23]
b. 17 Dec 1858 d. 11 Jul 1938
10
Luella Gollaher Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.24]
b. 12 Nov 1860 d. 22 Jul 1881
10
William C Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.25]
b. 11 Nov 1862 d. Sep 1937
10
Hyrum Smith Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.26]
b. 3 May 1864 d. 4 May 1935
10
Edith Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.27]
b. 22 Apr 1867 d. 11 Feb 1925
10
Lizzie Gollaher Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.28]
b. 9 Jul 1869 d. 30 Jul 1946
Olive Mary Knight
b. 24 Jan 1830 d. 27 Mar 1905
10
Louisa Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.29]
b. 29 Jun 1852 d. 29 Nov 1878
10
Heber Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.30]
b. Abt 1860 d. Bef 1868
10
Moroni Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.31]
b. 5 Nov 1861 d. 8 Jan 1934
10
Lorenzo Taft Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.32]
b. 3 Aug 1863 d. 6 Nov 1950
10
Joseph Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.33]
b. 13 Jul 1865 d. 5 Jun 1941
10
Ida May Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.34]
b. 16 Apr 1867 d. 30 Jun 1929
10
Don Carlos Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.35]
b. 29 Sep 1869 d. 19 Jan 1935
Mary Marie Larsen
b. 19 Dec 1843 d. 21 Feb 1926
10
Walter Taft Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.36]
b. 17 Jun 1867 d. 6 Jun 1957
10
Henry Taft Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.2.37]
b. 19 Mar 1869 d. 24 Feb 1947
+
Desdemona Wadsworth Fullmer
b. 6 Oct 1809 d. 9 Feb 1886
+
Lucinda Burton
b. 22 Oct 1825 d. 1 Oct 1863
9
George Taft Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.3]
b. Abt 1813
Prudence Maria Gifford
b. Abt 1815
10
Walter Everet Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.3.1]
b. 13 Sep 1857 d. 29 Apr 1907
Laura Frances Caldwell
b. 1862
11
Laura Livice Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.3.1.1]
b. 9 Oct 1883 d. 14 Feb 1911
Robert K Plummer
b. 1848 d. 21 Sep 1930
12
Gertude K Plummer
[1.4.2.2.4.2.7.1.3.1.1.1]
b. 1903
12
George K Plummer
[1.4.2.2.4.2.7.1.3.1.1.2]
b. 1904
12
Nathan B Plummer
[1.4.2.2.4.2.7.1.3.1.1.3]
b. 24 Jan 1911 d. 16 Nov 1994
11
George T Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.3.1.2]
b. Feb 1885
+
Ida N Steele
b. 9 Jan 1885
9
Hannah Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.4]
b. 18 Sep 1816
Henry Dodge
b. 15 Dec 1812 d. 22 Jun 1883
10
John M Dodge
[1.4.2.2.4.2.7.1.4.1]
b. 1838 d. 14 Feb 1898
10
Abbie R Dodge
[1.4.2.2.4.2.7.1.4.2]
b. 1850 d. 27 Sep 1916
John Averell
b. 1846 d. 19 Aug 1895
11
Elizabeth Alice Averell
[1.4.2.2.4.2.7.1.4.2.1]
b. 13 Apr 1884 d. 4 Feb 1901
+
William Cotter Ball
b. 1865
9
Abbie Ann Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.5]
b. Abt 1809 d. 21 Sep 1883
Calvin Rawson
b. 13 May 1797 d. 21 Jan 1868
10
Son Rawson
[1.4.2.2.4.2.7.1.5.1]
b. Abt 1828 d. Abt 1838
9
John M Benson
[1.4.2.2.4.2.7.1.6]
b. 1819 d. 12 Aug 1829
8
George Washington Benson
[1.4.2.2.4.2.7.2]
b. 25 May 1783 d. 10 Nov 1855
Alinda Warfield
b. 24 Aug 1785 d. 25 Apr 1841
9
Otis Benson
[1.4.2.2.4.2.7.2.1]
b. 28 Feb 1806 d. 16 Feb 1811
9
Harrison Benson
[1.4.2.2.4.2.7.2.2]
b. 10 Oct 1820 d. 25 Oct 1859
Marilla Adams
b. 12 Apr 1818 d. 16 Oct 1876
10
George Otis Benson
[1.4.2.2.4.2.7.2.2.1]
b. 24 Aug 1846 d. 2 May 1897
10
Reuben Benson
[1.4.2.2.4.2.7.2.2.2]
b. 1 Jan 1856 d. 25 Jul 1922
+
Marietta Ingraham Bliss
b. 27 Jun 1856 d. 21 Oct 1931
8
Jared Benson
[1.4.2.2.4.2.7.3]
b. 3 Feb 1785 d. 31 Jul 1854
Salley Taft
b. 21 Oct 1787 d. 7 Aug 1855
9
James Sulliven Benson
[1.4.2.2.4.2.7.3.1]
b. 19 Sep 1808 d. 3 Jan 1833
9
Putman Taft Benson
[1.4.2.2.4.2.7.3.2]
b. 28 Oct 1814 d. 24 Apr 1834
9
Jared Benson
[1.4.2.2.4.2.7.3.3]
b. 8 Nov 1821 d. 18 May 1894
Martha Taft
b. 23 Feb 1826 d. 19 Feb 1903
10
Sullivan Theodore Benson
[1.4.2.2.4.2.7.3.3.1]
b. 20 Apr 1844 d. 21 Sep 1911
10
Jared Irving Benson
[1.4.2.2.4.2.7.3.3.2]
b. 6 Oct 1846 d. 1919
Jenny Aiken Guild
b. 1852 d. 27 Oct 1906
11
Jared Curtis Benson
[1.4.2.2.4.2.7.3.3.2.1]
b. 6 Oct 1877
11
Frank Theodore Benson
[1.4.2.2.4.2.7.3.3.2.2]
b. 25 Feb 1878 d. Jul 1949
Ada Janette Foote
b. 5 Feb 1882 d. 10 Aug 1941
12
Donald Theodore Benson
[1.4.2.2.4.2.7.3.3.2.2.1]
b. 12 Jun 1903
12
Dorothy Martha Benson
[1.4.2.2.4.2.7.3.3.2.2.2]
b. 16 May 1904
12
Marjorie Emlyn Benson
[1.4.2.2.4.2.7.3.3.2.2.3]
b. 21 May 1906 d. 15 Feb 1977 [
=>
]
12
Eleanor Mae Benson
[1.4.2.2.4.2.7.3.3.2.2.4]
b. 7 Dec 1913 d. Apr 1980
10
Walter Bryant Benson
[1.4.2.2.4.2.7.3.3.3]
b. 16 Jan 1850 d. 10 Feb 1860
10
Grace Sally Benson
[1.4.2.2.4.2.7.3.3.4]
b. 2 Sep 1852 d. 25 Feb 1863
9
Sylvanus Holbrook Benson
[1.4.2.2.4.2.7.3.4]
b. 23 Jun 1828 d. 1878
Laurett V Howard
b. 1830 d. 1860
10
Ellen Laura Benson
[1.4.2.2.4.2.7.3.4.1]
b. 18 Aug 1851
George Hawes Lapham
b. 12 Jul 1849
11
Hattie Cobb Lapham
[1.4.2.2.4.2.7.3.4.1.1]
b. 21 Oct 1873 d. 13 Jun 1906
11
Albert Francis Lapham
[1.4.2.2.4.2.7.3.4.1.2]
b. 11 Dec 1876
Ida Luella Bradshaw
b. Abt 1881
12
Beatrice Fairbanks Lapham
[1.4.2.2.4.2.7.3.4.1.2.1]
b. 5 Jul 1904
12
Louise Frances Lapham
[1.4.2.2.4.2.7.3.4.1.2.2]
b. 4 Jun 1909
11
Frank Atwood Lapham
[1.4.2.2.4.2.7.3.4.1.3]
b. 2 Oct 1878
11
Frederick Lapham
[1.4.2.2.4.2.7.3.4.1.4]
b. 2 Sep 1880
11
Daughter Lapham
[1.4.2.2.4.2.7.3.4.1.5]
b. 19 Nov 1882
11
William Lapham
[1.4.2.2.4.2.7.3.4.1.6]
b. 29 Apr 1884 d. Bef 1890
11
Teresa Lapham
[1.4.2.2.4.2.7.3.4.1.7]
b. 10 Dec 1886
11
William Lapham
[1.4.2.2.4.2.7.3.4.1.8]
b. 5 Nov 1890 d. 24 May 1898
10
Ernest S Benson
[1.4.2.2.4.2.7.3.4.2]
b. 25 May 1855
+
Ida Cornelia Furbish
b. 1858
10
Laurett Victoria Howard Benson
[1.4.2.2.4.2.7.3.4.3]
b. 1859 d. 3 Jul 1883
Ezra Hunt Bailey
b. 23 Dec 1853 d. 3 May 1929
11
Edith L Bailey
[1.4.2.2.4.2.7.3.4.3.1]
b. 19 Jan 1881 d. 1962
+
Frederick Herbert
b. 29 Apr 1874
Lottie E. Kelly
10
Lottie E. Benson
[1.4.2.2.4.2.7.3.4.4]
b. 20 Sep 1866
8
Abigail Benson
[1.4.2.2.4.2.7.4]
b. 13 Feb 1787
Putman Taft
b. 5 Aug 1783 d. 20 Feb 1810
9
Mary Ann Taft
[1.4.2.2.4.2.7.4.1]
b. 23 Oct 1807
+
Samuel T Holroyd
b. 1791 d. 4 Nov 1817
+
Angel Sweet
b. 7 Apr 1790 d. 28 Apr 1825
+
Edward Ide Bower
+
Joseph McDermott
8
Mary "Polly" Benson
[1.4.2.2.4.2.7.5]
b. 9 Jun 1788 d. 12 Jan 1864
Bailey Legg
b. 9 May 1783 d. 11 Oct 1862
9
Sylvanus B Legg
[1.4.2.2.4.2.7.5.1]
b. 20 Jun 1813 d. Bef 8 Jun 1885
9
Mary H Legg
[1.4.2.2.4.2.7.5.2]
b. 7 Jul 1815
9
Harriet H Legg
[1.4.2.2.4.2.7.5.3]
b. 14 Jun 1817
8
Phyba Benson
[1.4.2.2.4.2.7.6]
b. Abt 1790
8
Prudence Benson
[1.4.2.2.4.2.7.7]
b. 7 Jul 1795
8
Thankful Benson
[1.4.2.2.4.2.7.8]
b. 26 Nov 1799 d. 1 May 1852
Joseph Bartlett Cook
b. 3 Dec 1796 d. 6 Oct 1856
9
William Walker Cook
[1.4.2.2.4.2.7.8.1]
b. 21 Mar 1820
Nancy Marion Draper
b. 17 Mar 1823
10
Edwin L Cook
[1.4.2.2.4.2.7.8.1.1]
b. 29 Mar 1857
+
Elisabeth M Campbell
b. Abt 1848
9
Amanda Melvina Cook
[1.4.2.2.4.2.7.8.2]
b. 12 Oct 1821
9
Mary Adeliza Cook
[1.4.2.2.4.2.7.8.3]
b. 18 Apr 1824
9
Emily Caroline Cook
[1.4.2.2.4.2.7.8.4]
b. 8 Feb 1826 d. 7 Mar 1826
9
Elma Ann Cook
[1.4.2.2.4.2.7.8.5]
b. 29 Jan 1827 d. 13 Jan 1870
William Gibbs Comstock
b. 3 Feb 1827 d. 29 Apr 1914
10
Alice Ardella Comstock
[1.4.2.2.4.2.7.8.5.1]
b. 10 Dec 1850 d. 20 Sep 1914
Sandford Phipps
b. 25 Aug 1850 d. 1919
11
Ross Elliot Phipps
[1.4.2.2.4.2.7.8.5.1.1]
b. 3 Sep 1877 d. 31 May 1958
Elouise G Gibbs
b. 2 Jul 1884 d. 10 Sep 1960
12
Nelson Sanford Phipps
[1.4.2.2.4.2.7.8.5.1.1.1]
b. 29 Dec 1912 d. 20 Mar 2003
12
Ross E Phipps
[1.4.2.2.4.2.7.8.5.1.1.2]
b. 18 Jun 1915 d. 26 May 1999 [
=>
]
11
Edith Ardella Phipps
[1.4.2.2.4.2.7.8.5.1.2]
b. 12 Sep 1879
+
Irvin Grover Lincoln
b. 30 Aug 1888
11
George Curtis Phipps
[1.4.2.2.4.2.7.8.5.1.3]
b. 25 Feb 1882 d. 4 Aug 1962
+
Anna Violet Sharp
b. 1887
10
Fanny Amanda Comstock
[1.4.2.2.4.2.7.8.5.2]
b. 4 Jul 1854 d. 2 Sep 1934
8
Sulvanus Holbrook Benson
[1.4.2.2.4.2.7.9]
b. 12 Jan 1797 d. 24 Aug 1812
8
Judson Benson
[1.4.2.2.4.2.7.10]
b. Abt 1801 d. 15 Oct 1813
7
Stephen Holbrook
[1.4.2.2.4.2.8]
b. 19 Jun 1764 d. 16 Aug 1830
Hope Albee
b. Abt 1765 d. 18 Jan 1840
8
Rachel Holbrook
[1.4.2.2.4.2.8.1]
b. 22 Apr 1789
8
Sylvanus Holbrook
[1.4.2.2.4.2.8.2]
b. 28 Jul 1792 d. 9 Dec 1855
8
Willard Holbrook
[1.4.2.2.4.2.8.3]
b. 7 Apr 1795 d. 4 Mar 1862
8
Wilder Holbrook
[1.4.2.2.4.2.8.4]
b. 7 Apr 1795 d. 2 Jan 1855
8
Chloe Holbrook
[1.4.2.2.4.2.8.5]
b. 13 Aug 1801 d. 11 Aug 1855
8
Henry Holbrook
[1.4.2.2.4.2.8.6]
b. 19 Apr 1804 d. 10 Jul 1874
8
Ellery Holbrook
[1.4.2.2.4.2.8.7]
b. 26 Jun 1810 d. 10 Jul 1847
7
Abigail Holbrook
[1.4.2.2.4.2.9]
b. 13 Sep 1765
7
Henry Holbrook
[1.4.2.2.4.2.10]
b. 11 Feb 1768 d. 18 Dec 1868
+
Barbara Thayer
b. 27 Feb 1770
7
Lucy Holbrook
[1.4.2.2.4.2.11]
b. 13 Sep 1770 d. 29 Jan 1843
Abner Adams
b. 4 Nov 1757 d. Aft 1831
8
Silvanus Adams
[1.4.2.2.4.2.11.1]
b. 7 Oct 1796 d. 6 Feb 1872
8
Washington Adams
[1.4.2.2.4.2.11.2]
b. 11 Dec 1799
8
Ruth Adams
[1.4.2.2.4.2.11.3]
b. 11 May 1802
8
Harriet Thayer Adams
[1.4.2.2.4.2.11.4]
b. 8 Oct 1804 d. 29 Oct 1825
8
Abner Adams
[1.4.2.2.4.2.11.5]
b. 11 Feb 1806
8
Judson Adams
[1.4.2.2.4.2.11.6]
b. 23 Mar 1808 d. 1843
8
Washington Adams
[1.4.2.2.4.2.11.7]
b. 1810
8
Zebediah Adams
[1.4.2.2.4.2.11.8]
b. 3 Aug 1814 d. 3 Apr 1815
6
John Holbrook
[1.4.2.2.4.3]
b. 1 Aug 1717 d. 1773
Zilphah Thayer
b. 14 Sep 1722 d. 1761
7
Micah Holbrook
[1.4.2.2.4.3.1]
b. 11 Mar 1744
7
Amariah Holbrook
[1.4.2.2.4.3.2]
b. Abt 1745 d. 20 Jan 1817
7
John Holbrook
[1.4.2.2.4.3.3]
b. Jun 1748
7
Catharina Holbrook
[1.4.2.2.4.3.4]
b. Abt 1752 d. 1752
7
Rhoda Holbrook
[1.4.2.2.4.3.5]
b. 25 Aug 1758 d. 1807
6
Sarah Holbrook
[1.4.2.2.4.4]
b. Abt 1719 d. 1800
Peter Thayer
b. 16 Apr 1720 d. Aft 1761
7
Naomi Thayer
[1.4.2.2.4.4.1]
b. 4 Jul 1751
Stephen Corrary
b. 16 Dec 1746
8
Sarah Crary
[1.4.2.2.4.4.1.1]
b. 21 Jul 1769
8
Ruth Crary
[1.4.2.2.4.4.1.2]
b. 18 Feb 1771
8
Phoebe Crary
[1.4.2.2.4.4.1.3]
b. 21 May 1775
8
Chloe Crary
[1.4.2.2.4.4.1.4]
b. 21 Apr 1777
8
Joanna Crary
[1.4.2.2.4.4.1.5]
b. 7 Feb 1779
8
Rachel Crary
[1.4.2.2.4.4.1.6]
b. 18 Jun 1780
8
Phoebe Crary
[1.4.2.2.4.4.1.7]
b. 13 May 1782
8
Stephen Crary
[1.4.2.2.4.4.1.8]
b. 1 Jun 1784
8
Sullivan Crary
[1.4.2.2.4.4.1.9]
b. 18 Apr 1786
7
Reuben Thayer
[1.4.2.2.4.4.2]
b. 27 Jun 1753 d. 9 Jun 1804
Abigail Wood
b. 30 Aug 1759 d. 22 Jun 1845
8
Chloe Thayer
[1.4.2.2.4.4.2.1]
b. 8 Nov 1781 d. Abt 1870
Archibald Clark
b. Abt 1770 d. 3 Nov 1821
9
Betsey Clark
[1.4.2.2.4.4.2.1.1]
b. Abt 1800
9
Sophia Clark
[1.4.2.2.4.4.2.1.2]
b. Abt 1802
9
Archibald Clark
[1.4.2.2.4.4.2.1.3]
b. Abt 1804
9
Sarah Clark
[1.4.2.2.4.4.2.1.4]
b. Abt 1806
9
Abigail Clark
[1.4.2.2.4.4.2.1.5]
b. Abt 1808
9
Chloe Clark
[1.4.2.2.4.4.2.1.6]
b. Abt 1812
9
Augusta Clark
[1.4.2.2.4.4.2.1.7]
b. Abt 1814
9
Josephine Clark
[1.4.2.2.4.4.2.1.8]
b. Abt 1816
9
Zephrona Clark
[1.4.2.2.4.4.2.1.9]
b. Abt 1818
8
Abigail Thayer
[1.4.2.2.4.4.2.2]
b. 11 Oct 1782
Martin Lewis
b. Abt 1779
9
Archibald Lewis
[1.4.2.2.4.4.2.2.1]
b. Abt 1802
9
Alexander Lewis
[1.4.2.2.4.4.2.2.2]
b. Abt 1805
9
Louisa Lewis
[1.4.2.2.4.4.2.2.3]
b. Abt 1807
9
Emma Lewis
[1.4.2.2.4.4.2.2.4]
b. Abt 1809
9
William Lewis
[1.4.2.2.4.4.2.2.5]
b. Abt 1811
9
Martin Lewis
[1.4.2.2.4.4.2.2.6]
b. Abt 1813
9
Abigail Lewis
[1.4.2.2.4.4.2.2.7]
b. Abt 1815
9
Eveline Lewis
[1.4.2.2.4.4.2.2.8]
b. Abt 1817
9
David Lewis
[1.4.2.2.4.4.2.2.9]
b. Abt 1819
8
Eunice Thayer
[1.4.2.2.4.4.2.3]
b. May 1785 d. Mar 1790
8
Reuben Thayer
[1.4.2.2.4.4.2.4]
b. 6 Oct 1786 d. 8 Nov 1860
Mary Vandervater
b. Abt 1792 d. 2 Oct 1845
9
Abigail Thayer
[1.4.2.2.4.4.2.4.1]
b. 1814
Milton M Morris
b. Abt 1810 d. 1837
10
Caroline Morris
[1.4.2.2.4.4.2.4.1.1]
b. 1834
Lorenzo D Harvey
b. Abt 1810
10
Henry Harvey
[1.4.2.2.4.4.2.4.1.2]
b. 1 Jul 1843 d. 1861
10
Frances M Harvey
[1.4.2.2.4.4.2.4.1.3]
b. 1 Jan 1845
10
Kate Harvey
[1.4.2.2.4.4.2.4.1.4]
b. 1847
9
Mary Thayer
[1.4.2.2.4.4.2.4.2]
b. Abt 1817
9
Daniel V Thayer
[1.4.2.2.4.4.2.4.3]
b. 24 Mar 1820 d. 1880
Nancy R Cook
b. 7 Jun 1823 d. 15 Jun 1899
10
George W Thayer
[1.4.2.2.4.4.2.4.3.1]
b. 26 Sep 1845 d. 1855
10
Mary Jane Thayer
[1.4.2.2.4.4.2.4.3.2]
b. 16 Feb 1848 d. 1 Oct 1850
10
Harriet Thayer
[1.4.2.2.4.4.2.4.3.3]
b. 14 Jan 1851
10
Edward Thayer
[1.4.2.2.4.4.2.4.3.4]
b. 17 Nov 1853
10
Carrie Thayer
[1.4.2.2.4.4.2.4.3.5]
b. 7 Aug 1857 d. 11 Sep 1857
10
Frank Cook Thayer
[1.4.2.2.4.4.2.4.3.6]
b. 24 Jun 1862
9
Joshua G Thayer
[1.4.2.2.4.4.2.4.4]
b. 24 Nov 1823 d. 14 Dec 1878
Adelia M Barker
b. 1 Dec 1828
10
Jane Thayer
[1.4.2.2.4.4.2.4.4.1]
b. 17 Jan 1847
10
Charles A Thayer
[1.4.2.2.4.4.2.4.4.2]
b. 1 Nov 1848
10
Abigail L Thayer
[1.4.2.2.4.4.2.4.4.3]
b. 14 Jan 1851
10
William S Thayer
[1.4.2.2.4.4.2.4.4.4]
b. 7 Dec 1852
10
Thomas D Thayer
[1.4.2.2.4.4.2.4.4.5]
b. 29 Aug 1855
10
Mary E Thayer
[1.4.2.2.4.4.2.4.4.6]
b. 1 Nov 1859
9
Joseph C Thayer
[1.4.2.2.4.4.2.4.5]
b. 9 Mar 1827 d. 28 Oct 1886
Lucretia Chambers
b. 22 May 1829 d. Bef Jun 1880
10
Mary E Thayer
[1.4.2.2.4.4.2.4.5.1]
b. 31 Aug 1850 d. 7 Jun 1857
10
John C Thayer
[1.4.2.2.4.4.2.4.5.2]
b. 24 Jul 1852 d. 23 Jul 1861
10
George A Thayer
[1.4.2.2.4.4.2.4.5.3]
b. 14 Nov 1855
10
Susan M Thayer
[1.4.2.2.4.4.2.4.5.4]
b. 28 Jul 1857 d. 8 Feb 1907
10
Benjamin F Thayer
[1.4.2.2.4.4.2.4.5.5]
b. 4 Oct 1864
9
John S Thayer
[1.4.2.2.4.4.2.4.6]
b. 12 Nov 1829
9
Amanda Thayer
[1.4.2.2.4.4.2.4.7]
b. 1833 d. 1836
8
Salley Thayer
[1.4.2.2.4.4.2.5]
b. 9 Feb 1790 d. 1835
+
Nathaniel S White
b. Abt 1789
8
Sylvanus Thayer
[1.4.2.2.4.4.2.6]
b. 1793
8
Eunice Thayer
[1.4.2.2.4.4.2.7]
b. 5 Mar 1797
Staley Nichols Clarke
b. 24 Mar 1794 d. 14 Oct 1860
9
Sarah E Clarke
[1.4.2.2.4.4.2.7.1]
b. 9 Aug 1817
9
Fayette Clarke
[1.4.2.2.4.4.2.7.2]
b. 17 Aug 1819
9
Mary D Clarke
[1.4.2.2.4.4.2.7.3]
b. 7 Dec 1820
9
Archibald Clarke
[1.4.2.2.4.4.2.7.4]
b. 20 Mar 1823 d. 13 Mar 1846
9
Dlyden Clarke
[1.4.2.2.4.4.2.7.5]
b. 26 May 1825
9
Stacy Nichols Clarke
[1.4.2.2.4.4.2.7.6]
b. 21 Aug 1828 d. 20 Feb 1861
9
Abigail W Clarke
[1.4.2.2.4.4.2.7.7]
b. 29 Sep 1830
9
Theadora Clarke
[1.4.2.2.4.4.2.7.8]
b. 11 Feb 1833
9
Emma M Clarke
[1.4.2.2.4.4.2.7.9]
b. 25 Feb 1835
9
William T Clarke
[1.4.2.2.4.4.2.7.10]
b. 20 Jul 1837
8
George Washington Thayer
[1.4.2.2.4.4.2.8]
b. 5 Aug 1799 d. 7 Mar 1865
Martha C Clemmons
b. 13 Mar 1803 d. 11 Apr 1851
9
George W Thayer
[1.4.2.2.4.4.2.8.1]
b. 28 Apr 1826
9
Sylvanus Thayer
[1.4.2.2.4.4.2.8.2]
b. 2 Dec 1827
9
Lucinda Thayer
[1.4.2.2.4.4.2.8.3]
b. 23 Apr 1829
9
Abigail Thayer
[1.4.2.2.4.4.2.8.4]
b. 7 Mar 1830 d. 1853
9
Reuben R Thayer
[1.4.2.2.4.4.2.8.5]
b. 27 Mar 1832 d. 17 Aug 1903
9
Mary Thayer
[1.4.2.2.4.4.2.8.6]
b. 9 Jul 1834 d. 17 Apr 1835
9
Theodore Thayer
[1.4.2.2.4.4.2.8.7]
b. 21 Dec 1835 d. 1911
9
Chauncy Thayer
[1.4.2.2.4.4.2.8.8]
b. 1 Sep 1837
9
Mary Thayer
[1.4.2.2.4.4.2.8.9]
b. 30 Mar 1840 d. 11 Apr 1846
9
Frances Thayer
[1.4.2.2.4.4.2.8.10]
b. 5 Jul 1842
9
Elizabeth
[1.4.2.2.4.4.2.8.11]
b. 14 Mar 1846 d. 9 Mar 1847
7
Peter Thayer
[1.4.2.2.4.4.3]
b. 2 Oct 1755 d. 1820
Abigail Green
b. 4 Oct 1765 d. 1830
8
Betsy Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.1]
b. 14 Jul 1784 d. 7 Aug 1821
William Daniels
b. Abt 1779 d. 3 Sep 1850
9
Mariana M Daniels
[1.4.2.2.4.4.3.1.1]
b. 20 Jul 1806
9
Ora S Daniels
[1.4.2.2.4.4.3.1.2]
b. 5 Feb 1808
9
Catharine M Daniels
[1.4.2.2.4.4.3.1.3]
b. 17 Mar 1810
9
William A Daniels
[1.4.2.2.4.4.3.1.4]
b. 2 May 1814
9
John L Daniels
[1.4.2.2.4.4.3.1.5]
b. 31 Jan 1816
9
Peter D Daniels
[1.4.2.2.4.4.3.1.6]
b. 20 May 1817
9
Marvin N Daniels
[1.4.2.2.4.4.3.1.7]
b. 21 Mar 1819
9
Mary E Daniels
[1.4.2.2.4.4.3.1.8]
b. 30 Jan 1821
8
Emery Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2]
b. 27 Jan 1786 d. 19 May 1851
Lydia Mobbs
b. 10 May 1805
9
Martin B Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2.1]
b. 13 Dec 1826
+
Laura Burton
b. 1828
9
Ora Sophronia Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2.2]
b. 3 Jan 1827 d. 26 Jan 1864
Joseph Ferguson
b. 30 Nov 1819 d. 19 Sep 1893
10
Robert Emory Ferguson
[1.4.2.2.4.4.3.2.2.1]
b. 1848 d. 26 Jan 1864
10
Julie E Farguson
[1.4.2.2.4.4.3.2.2.2]
b. 14 Nov 1849 d. 1 May 1917
10
George Thomas Ferguson
[1.4.2.2.4.4.3.2.2.3]
b. 10 Feb 1854 d. 8 Aug 1916
10
Jane Ferguson
[1.4.2.2.4.4.3.2.2.4]
b. 1856
10
John Jasper Ferguson
[1.4.2.2.4.4.3.2.2.5]
b. 1 Mar 1856 d. 6 Feb 1935
10
Edward Ferguson
[1.4.2.2.4.4.3.2.2.6]
b. 1858
10
Mary Saphronia Ferguson
[1.4.2.2.4.4.3.2.2.7]
b. 1861
10
Joseph Delbert Ferguson
[1.4.2.2.4.4.3.2.2.8]
b. Mar 1863
10
Daughter Ferguson
[1.4.2.2.4.4.3.2.2.9]
b. Mar 1863 d. Mar 1863
9
Asahel William Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2.3]
b. 12 Jan 1829 d. Bef 1900
Ellen Ferrell
b. 25 Jun 1831
10
William E Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2.3.1]
b. 2 Jul 1854 d. 30 May 1855
10
Mary Ellen Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2.3.2]
b. 13 Mar 1856
Edwin J Durfee
b. 5 Aug 1855
11
Estella May Durfee
[1.4.2.2.4.4.3.2.3.2.1]
b. 15 Jan 1876 d. 6 Mar 1963
Merritt Pendell Whipple
b. 22 Apr 1875 d. 3 Oct 1936
12
Arthur Paul Whipple
[1.4.2.2.4.4.3.2.3.2.1.1]
b. 17 Jul 1901 d. 25 Nov 1937 [
=>
]
12
Helen Estelle Whipple
[1.4.2.2.4.4.3.2.3.2.1.2]
b. 18 Dec 1905 d. 1 Feb 1979
12
Virginia Dallas Whipple
[1.4.2.2.4.4.3.2.3.2.1.3]
b. 25 Jun 1907 d. 8 Feb 1995
12
Ralph Alfred Whipple
[1.4.2.2.4.4.3.2.3.2.1.4]
b. 10 Jul 1909
11
Walter Chesley Durfee
[1.4.2.2.4.4.3.2.3.2.2]
b. 28 Sep 1879 d. 7 Dec 1884
10
Henry Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2.3.3]
b. 22 Feb 1858 d. 3 Apr 1858
10
Addie Catherine Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2.3.4]
b. 11 Mar 1859 d. 9 Oct 1859
10
William Lawrence Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2.3.5]
b. 1 Oct 1860 d. 18 Jun 1934
Clara Elizabeth Brunk
b. 5 Mar 1861 d. 28 Nov 1951
11
Carrie Belle Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2.3.5.1]
b. 21 Dec 1884 d. 19 Mar 1972
David Richard Thomas
b. 22 Jul 1890 d. 26 May 1965
12
John Lawrence Thomas
[1.4.2.2.4.4.3.2.3.5.1.1]
b. 16 Sep 1918 d. 20 Jun 2002
11
Florence Estella Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2.3.5.2]
b. 5 Oct 1886 d. 30 Mar 1965
11
Lawrence Michael Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2.3.5.3]
b. 11 Feb 1888 d. 30 Jun 1955
10
Fannie A Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2.3.6]
b. 25 Jan 1863
10
Michael R Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2.3.7]
b. 20 Mar 1865 d. 2 Jul 1867
10
Asa W Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2.3.8]
b. 9 Aug 1865 d. 16 Nov 1947
10
John R Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2.3.9]
b. 19 Feb 1870 d. 14 Sep 1870
9
Samuel Allen Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2.4]
b. 19 Dec 1830 d. Abt 5 Sep 1909
9
William Henry Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2.5]
b. 5 Mar 1833 d. 4 Jul 1911
Ladiska Alice Thurston
b. 1838
10
George A Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2.5.1]
b. Aug 1859 d. 17 Mar 1923
+
Elizabeth Neal
b. 1870 d. 18 Nov 1940
10
Leo Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2.5.2]
b. Abt 1860
10
Frank L Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2.5.3]
b. 1861
Jennie Fuzey
b. Jun 1860
11
Nina May Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2.5.3.1]
b. Nov 1882
11
Lulu Blanche Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2.5.3.2]
b. Jun 1884
11
Rhoda Leona Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2.5.3.3]
b. Aug 1885
11
Frank William Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2.5.3.4]
b. 5 Sep 1887 d. 17 Sep 1962
11
Robert James Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2.5.3.5]
b. Jun 1889
11
Ella Izata Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2.5.3.6]
b. Apr 1891
11
Charles Alverton Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2.5.3.7]
b. 17 Sep 1892 d. 18 Oct 1961
Olive E Rowe
b. 15 Oct 1890 d. 22 May 1988
12
John Burnham Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2.5.3.7.1]
b. 12 Feb 1923 d. 15 Jan 2002
10
Charles Ellsworth Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2.5.4]
b. Feb 1862
Anna Marie Murphy
b. Sep 1864
11
Alfred William Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2.5.4.1]
b. 27 Dec 1892 d. 20 Jun 1956
Alice O'Brien
b. 23 Nov 1890 d. 24 Oct 1957
12
Ethel Marie Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2.5.4.1.1]
b. 23 Oct 1921 d. 17 Apr 1995
12
Anna Jane Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2.5.4.1.2]
b. 6 May 1923 d. 3 Jun 1988
12
Dorothy Alice Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2.5.4.1.3]
b. 18 Jun 1924 d. 31 Oct 1998
12
William Arthur Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2.5.4.1.4]
b. 17 Jan 1926 d. 24 Oct 1992
12
Margaret Ellen Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2.5.4.1.5]
b. 4 Jan 1927 d. May 2004 [
=>
]
12
Charles Edward Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2.5.4.1.6]
b. 23 Jul 1928 d. 30 Oct 1999
11
Florence Marie Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2.5.4.2]
b. 18 Jul 1893 d. May 1974
+
Joseph Vincent Bentz
b. 1891
11
Son Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2.5.4.3]
b. 1896 d. 1898
11
Ralph Leo Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2.5.4.4]
b. 1 Sep 1897 d. 7 Mar 1957
10
Mabel G Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2.5.5]
b. Abt 1872
10
Myrtle L Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2.5.6]
b. Abt 1877
9
Charles Edwin Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2.6]
b. 15 May 1835
Elinor Jane Walden
b. Aug 1845 d. 1919
10
Wilson Wilsey Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2.6.1]
b. 27 Jan 1866 d. 24 Jun 1897
10
Lewis William Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2.6.2]
b. 3 Oct 1872 d. 3 May 1951
10
Edwin Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2.6.3]
b. Abt 1874
9
Anna Valina Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2.7]
b. 23 Dec 1838 d. 28 Feb 1902
Hill
b. Abt 1834 d. Abt 1864
10
Daughter Hill
[1.4.2.2.4.4.3.2.7.1]
b. Abt 1861 d. Bef 1870
10
Ada B Hill
[1.4.2.2.4.4.3.2.7.2]
b. 1862 d. Bef 1875
Joseph Ferguson
b. 30 Nov 1819 d. 19 Sep 1893
10
Minnie Mae Ferguson
[1.4.2.2.4.4.3.2.7.3]
b. 1867
10
Samuel Ferguson
[1.4.2.2.4.4.3.2.7.4]
b. 1869
10
James F Ferguson
[1.4.2.2.4.4.3.2.7.5]
b. 1873
10
Hal Ferguson
[1.4.2.2.4.4.3.2.7.6]
b. 1876
9
Harriet Phebe Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2.8]
b. 3 Jan 1841 bur. 4 May 1888
Thomas Henry Jones
b. 1835 d. 11 Mar 1892
10
George Henry Jones
[1.4.2.2.4.4.3.2.8.1]
b. Aug 1856 d. 25 Feb 1932
10
Martha Anne Jones
[1.4.2.2.4.4.3.2.8.2]
b. 26 Mar 1857 d. 28 May 1935
Alfred Tewksbury
b. 9 May 1852 d. 16 Oct 1928
11
Minnie Maud Tewksbury
[1.4.2.2.4.4.3.2.8.2.1]
b. 9 Mar 1878 d. Bef 1960
11
Leslie Roy Tewksbury
[1.4.2.2.4.4.3.2.8.2.2]
b. 31 Jan 1888 d. Jan 1976
10
Mary Eva Jones
[1.4.2.2.4.4.3.2.8.3]
b. 5 Mar 1860 d. 8 Nov 1874
10
Amos Peter Jones
[1.4.2.2.4.4.3.2.8.4]
b. 2 Oct 1863 d. 7 Jul 1948
Alice Mae McCartney
b. 14 Dec 1863 d. 8 Aug 1947
11
Charles Frederick Jones
[1.4.2.2.4.4.3.2.8.4.1]
b. 7 Mar 1887 d. 24 Nov 1948
+
Mary Ann Broke
b. 22 Feb 1888
11
Henry Harrison Jones
[1.4.2.2.4.4.3.2.8.4.2]
b. 5 Oct 1888 d. 9 May 1949
+
Della Norman
b. 1887 d. Nov 1928
11
John Thomas Jones
[1.4.2.2.4.4.3.2.8.4.3]
b. 13 Jul 1890 d. Aft 1963
+
Martha Waltz
b. 23 Aug 1893
11
Carrie Eva Jones
[1.4.2.2.4.4.3.2.8.4.4]
b. 16 Nov 1892 d. 30 Aug 1976
+
John David Martin
b. 3 Jan 1880 d. Jun 1965
11
Mabel Ruth Jones
[1.4.2.2.4.4.3.2.8.4.5]
b. 23 Nov 1894 d. 21 Jul 1945
Oscar Theo Smith
b. Apr 1888 d. Jun 1949
12
Carl Lewis Smith
[1.4.2.2.4.4.3.2.8.4.5.1]
b. 17 Mar 1916 d. 16 Oct 1963
12
Mary Louise Smith
[1.4.2.2.4.4.3.2.8.4.5.2]
b. 8 Nov 1921 d. 26 Jul 2001
12
Betty J Smith
[1.4.2.2.4.4.3.2.8.4.5.3]
b. 20 Feb 1925 d. 16 Jan 2001
11
Blanche Mae Jones
[1.4.2.2.4.4.3.2.8.4.6]
b. 8 May 1897 d. 27 Nov 1976
Charles Columbus Samson
b. 14 Sep 1893 d. 10 Oct 1964
12
Living
[1.4.2.2.4.4.3.2.8.4.6.1]
12
Living
[1.4.2.2.4.4.3.2.8.4.6.2]
[
=>
]
12
Alice Marie Samson
[1.4.2.2.4.4.3.2.8.4.6.3]
b. 17 Jul 1934 d. 10 Dec 1994
12
Lillian Emeretta Samson
[1.4.2.2.4.4.3.2.8.4.6.4]
b. 6 Feb
12
Anna Mae Samson
[1.4.2.2.4.4.3.2.8.4.6.5]
b. 24 Aug
12
Charles Columbus Samson, Jr
[1.4.2.2.4.4.3.2.8.4.6.6]
b. 28 Aug
12
Amos Dale Samson
[1.4.2.2.4.4.3.2.8.4.6.7]
b. 14 Dec
11
Nellie Pearl Jones
[1.4.2.2.4.4.3.2.8.4.7]
b. 9 Jan 1900 d. Dec 1954
+
Orville A Weir
b. Abt 1900
11
Frank Willie Jones
[1.4.2.2.4.4.3.2.8.4.8]
b. 23 Feb 1902 d. 4 Oct 1945
11
Amos McCartney Jones
[1.4.2.2.4.4.3.2.8.4.9]
b. 23 Jun 1905 d. 30 Jan 1986
11
Alice Elizabeth Jones
[1.4.2.2.4.4.3.2.8.4.10]
b. 16 Jul 1908 d. 15 Sep 1990
10
Ella Maria Jones
[1.4.2.2.4.4.3.2.8.5]
b. Jun 1864 d. 14 May 1936
Charles Freemont Yeoman
b. 26 Jan 1857 d. 19 Sep 1914
11
Bert William Yeoman
[1.4.2.2.4.4.3.2.8.5.1]
b. 12 Jun 1883 d. 29 Sep 1964
11
Cora Sophia Yeoman
[1.4.2.2.4.4.3.2.8.5.2]
b. 24 Oct 1884 d. 30 Sep 1970
Joseph Lorraine Bagley
b. 18 Nov 1872 d. 1 Mar 1942
12
Joseph Lorraine Bagley, Jr
[1.4.2.2.4.4.3.2.8.5.2.1]
b. 11 Mar 1909 d. 6 Aug 1988 [
=>
]
12
Grant Van Bagley
[1.4.2.2.4.4.3.2.8.5.2.2]
b. 8 Jul 1910 d. 19 May 1933 [
=>
]
12
Charles Freemont Bagley
[1.4.2.2.4.4.3.2.8.5.2.3]
b. 13 Oct 1914 d. 25 Oct 1914
12
Minerva Anne Bagley
[1.4.2.2.4.4.3.2.8.5.2.4]
b. 30 Mar 1917 d. 8 Jul 1992 [
=>
]
12
Vera LaVonne Bagley
[1.4.2.2.4.4.3.2.8.5.2.5]
b. 7 Oct 1918 d. 12 Jul 2002
12
Eleanore Elaine Bagley
[1.4.2.2.4.4.3.2.8.5.2.6]
b. 5 Sep 1921 d. 25 Jan 2014 [
=>
]
12
Earl Dale Bagley
[1.4.2.2.4.4.3.2.8.5.2.7]
b. 19 May 1924 d. 12 Mar 1925
11
Alta Ella Yeoman
[1.4.2.2.4.4.3.2.8.5.3]
b. 16 Jul 1886
11
Eighty Eight Ann Yeoman
[1.4.2.2.4.4.3.2.8.5.4]
b. 4 Mar 1888
11
Golda Iona Yeoman
[1.4.2.2.4.4.3.2.8.5.5]
b. 24 Jul 1896 d. 1947
11
Nina Marie Yeoman
[1.4.2.2.4.4.3.2.8.5.6]
b. 1 Jan 1899
10
Eliza Iona "Lizzie" Jones
[1.4.2.2.4.4.3.2.8.6]
b. 12 Jul 1868 d. 9 Feb 1933
10
Cora Lydia Jones
[1.4.2.2.4.4.3.2.8.7]
b. 8 May 1869 d. 12 Jan 1954
+
John E Thurlby
b. 12 Mar 1866 d. 26 Jan 1939
10
Franklin Harrison Jones
[1.4.2.2.4.4.3.2.8.8]
b. 1 Sep 1873 d. 18 Nov 1934
10
Charles Emory Jones
[1.4.2.2.4.4.3.2.8.9]
b. Feb 1875 d. 8 Jul 1955
9
Peter H Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2.9]
b. 26 Jul 1842 d. 20 Feb 1911
Eliza Devine
b. 1842
10
Texa N Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2.9.1]
b. Abt 1869
Franklin Samuel Hart
b. 7 Jan 1867 d. 15 Nov 1939
11
Marie L Hart
[1.4.2.2.4.4.3.2.9.1.1]
b. 28 Jun 1893
9
Louisa M Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2.10]
b. 26 Dec 1844
9
George Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2.11]
b. 1847
9
Son Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.2.12]
b. 16 Jun 1849
8
Samuel Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.3]
b. 30 Apr 1788 d. 1851
Phebe Allen
b. Abt 1790 d. Aug 1851
9
Calvin Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.3.1]
b. Abt 14 Sep 1806
Almena Roe
b. 8 Apr 1805 d. 1842
10
Erwin Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.3.1.1]
b. 15 Feb 1828
10
Phebe Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.3.1.2]
b. 12 Aug 1832
10
William Henry Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.3.1.3]
b. 15 Nov 1834 d. 17 Sep 1913
10
Harriet Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.3.1.4]
b. Abt 1837
10
Sheldon Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.3.1.5]
b. 22 Nov 1838 d. 1896
10
Edward Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.3.1.6]
b. 15 Aug 1840
10
Louisa Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.3.1.7]
b. Abt 1843
Mary Griffin
b. Abt 1820
10
Jennie Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.3.1.8]
b. 31 Jan 1854
9
Linas Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.3.2]
b. 28 Feb 1808 d. 28 Feb 1859
Elizabeth Cross
b. Abt 1812
10
Millie L C Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.3.2.1]
b. 15 Mar 1855 d. 19 Aug 1856
9
Abigail Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.3.3]
b. 19 Sep 1809
Horace Arnold
b. 22 Nov 1806 d. 15 Apr 1869
10
Francis E Arnold
[1.4.2.2.4.4.3.3.3.1]
b. 2 Aug 1834
10
Betsey Arnold
[1.4.2.2.4.4.3.3.3.2]
b. 16 Oct 1838
10
Nahum W Arnold
[1.4.2.2.4.4.3.3.3.3]
b. 18 Jan 1841
10
Harriet P Arnold
[1.4.2.2.4.4.3.3.3.4]
b. 29 May 1845
9
Elizabeth Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.3.4]
b. 13 Jan 1811 d. 1 Mar 1850
Datus Bush
b. 6 Jun 1804
10
Perry Franklin Bush
[1.4.2.2.4.4.3.3.4.1]
b. 29 Mar 1836
10
Phebe Ann Bush
[1.4.2.2.4.4.3.3.4.2]
b. 31 Jan 1838
10
Emily Bush
[1.4.2.2.4.4.3.3.4.3]
b. 17 Dec 1839 d. 5 Feb 1841
10
Paine Bush
[1.4.2.2.4.4.3.3.4.4]
b. 8 Oct 1841
10
Franklin Bush
[1.4.2.2.4.4.3.3.4.5]
b. 18 Sep 1843
10
George F Bush
[1.4.2.2.4.4.3.3.4.6]
b. 5 Mar 1846
10
Sarah P Bush
[1.4.2.2.4.4.3.3.4.7]
b. 17 Aug 1848 d. 4 Oct 1849
9
Oliver Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.3.5]
b. 3 May 1814
Harriet Thayer
b. 24 Sep 1817 d. 1874
10
Austin Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.3.5.1]
b. 5 Nov 1841
10
Abigail Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.3.5.2]
b. 20 Sep 1843
10
Catharina S Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.3.5.3]
b. 12 Feb 1846
10
Datus Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.3.5.4]
b. 11 Jul 1848
10
George Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.3.5.5]
b. 20 Feb 1850
10
Orrin Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.3.5.6]
b. 26 Oct 1852
10
Margaret Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.3.5.7]
b. 22 Jan 1855
10
Dayton Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.3.5.8]
b. 31 Jul 1857
10
Otis Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.3.5.9]
b. Abt 1863 d. 6 Aug 1938
9
Alonzo Peter Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.3.6]
b. 14 Jan 1816
Laura Alvina Thayer
b. 26 Nov 1827
10
George
[1.4.2.2.4.4.3.3.6.1]
b. 28 Sep 1846
10
Lorenzo Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.3.6.2]
b. 28 Jun 1848
10
Emily Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.3.6.3]
b. 24 Aug 1849
10
George Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.3.6.4]
b. 16 Nov 1851
10
Franklin Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.3.6.5]
b. 6 Mar 1852
10
Horace Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.3.6.6]
b. 18 Jan 1855 d. 1 Oct 1857
10
Willie Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.3.6.7]
b. 3 May 1857 d. 18 Oct 1860
8
Hyram Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.4]
b. Abt 1790
Elizabeth Perry
b. Abt 1779 d. 23 Mar 1854
9
Rebecca E Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.4.1]
b. 2 Apr 1830
9
George W Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.4.2]
b. 6 May 1832 d. 8 Oct 1854
9
Caroline C Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.4.3]
b. 2 Nov 1834
9
Nancy M Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.4.4]
b. 2 Apr 1838 d. 20 Sep 1848
8
John H Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.5]
b. 25 May 1791
Susan Mitchell Simmons
b. 6 Jun 1797 d. Jan 1872
9
Lucinda Ann Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.5.1]
b. 2 Nov 1826
Lewis Thayer
b. 6 Nov 1796
10
Lois Ann Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.5.1.1]
b. 5 Jan 1857 d. Abt 1933
8
Henry Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.6]
b. 23 Mar 1793 d. Abt 1825
Mercy Moon
b. Abt 1795
9
George Washington Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.6.1]
b. 27 Feb 1817 d. 29 Aug 1892
9
Robert Moon Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.6.2]
b. 27 Feb 1819 d. 14 Sep 1863
9
Mary Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.6.3]
b. 11 Jul 1821
Elizabeth Hall
b. Abt 1803 d. 8 Dec 1864
9
Henry Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.6.4]
b. 14 Mar 1831
9
Marvin S Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.6.5]
b. 19 Aug 1832
9
Ansley Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.6.6]
b. 1836
8
Peter Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.7]
b. 15 Jul 1795
Sarah McCrary
b. 9 Feb 1799
9
Emery Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.7.1]
b. 18 Dec 1816 d. 27 Oct 1885
Tamer Louise Ransom
b. 31 Oct 1821 d. May 1908
10
James A Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.7.1.1]
b. 27 Nov 1845
10
John Emory Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.7.1.2]
b. 18 Jul 1847 d. 28 Feb 1924
10
Alice C Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.7.1.3]
b. 17 Jun 1851
10
Peter B Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.7.1.4]
b. 7 Jan 1855
10
Erastus R Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.7.1.5]
b. 7 Jun 1858
9
Martin D Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.7.2]
b. 27 Sep 1818
Julia Ann Ames
b. 21 Apr 1824 d. 1893
10
Sarah Jane Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.7.2.1]
b. 2 Jul 1848
10
Arvilla C Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.7.2.2]
b. 6 Jan 1851
10
William D Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.7.2.3]
b. 6 Nov 1857
10
Ada Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.7.2.4]
b. 30 Aug 1862
9
Granderson F Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.7.3]
b. 17 Oct 1820
Mary E Fitch
b. 2 Feb 1831
10
Frank Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.7.3.1]
b. 29 Oct 1857
10
Herbert G Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.7.3.2]
b. 12 Mar 1860
9
Cyrena Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.7.4]
b. 27 Feb 1825
Edward Pierce
b. Abt 1821
10
Elliott M Pierce
[1.4.2.2.4.4.3.7.4.1]
b. 8 Feb 1846
10
Helen Irene Pierce
[1.4.2.2.4.4.3.7.4.2]
b. 25 Jul 1850
9
Lucretia E Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.7.5]
b. 19 Dec 1827
9
Squire M Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.7.6]
b. 3 May 1830
9
James A Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.7.7]
b. 26 Mar 1832
+
Josephine Eliza Hunger
b. 8 Mar 1833
8
Oliver Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.8]
b. 21 Oct 1796
8
Abigail Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.9]
b. 9 Jul 1803
8
Sylvanus Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.10]
b. 9 Aug 1806
Maria Handy Thayer
9
Emily Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.10.1]
b. 2 Sep 1830
9
Erastus Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.10.2]
b. 31 Oct 1831
9
Eliza A Thayer
[1.4.2.2.4.4.3.10.3]
b. 20 Mar 1833
7
Oliver Thayer
[1.4.2.2.4.4.4]
b. 9 Jul 1758
7
Silvanus Thayer
[1.4.2.2.4.4.5]
b. 4 Sep 1762
+
Diana Taft
b. 4 Sep 1767 d. 1830
7
Hannah Thayer
[1.4.2.2.4.4.6]
b. 8 Jul 1764
+
Joseph Crossman
b. Abt 1758
6
Catherine Holbrook
[1.4.2.2.4.5]
b. Abt 1721 d. 1740
Daniel Holbrook
b. 1717 d. 1765
7
Job Holbrook
[1.4.2.2.4.5.1]
b. 17 Mar 1751
7
Annah Holbrook
[1.4.2.2.4.5.2]
b. 2 Apr 1754
7
Phinehas Holbrook
[1.4.2.2.4.5.3]
b. 8 Apr 1760
7
Paul Holbrook
[1.4.2.2.4.5.4]
b. 29 Jan 1756
7
Peter Holbrook
[1.4.2.2.4.5.5]
b. 1 Mar 1745
7
Catharina Holbrook
[1.4.2.2.4.5.6]
b. 1752
7
Silas Holbrook
[1.4.2.2.4.5.7]
b. 11 Oct 1762
7
Daniel Holbrook
[1.4.2.2.4.5.8]
b. 6 Mar 1743 d. Bef 1758
7
Daniel Holbrook
[1.4.2.2.4.5.9]
b. 12 Mar 1758
6
Eunice Holbrook
[1.4.2.2.4.6]
b. 9 Aug 1735 d. Aft 1790
Moses Benson
b. 20 May 1732 d. 3 Jul 1806
7
Aaron Benson
[1.4.2.2.4.6.1]
b. 28 Oct 1753 d. 8 Jul 1827
Lydia Fairbanks
b. 1758 d. 30 Aug 1814
8
Alanson Benson
[1.4.2.2.4.6.1.1]
b. 1783 d. 7 Dec 1857
Lucina Lapham
b. Abt 1789 d. Nov 1853
9
Lucina Benson
[1.4.2.2.4.6.1.1.1]
b. 28 Jan 1832 d. 1 Jan 1916
8
Polly Benson
[1.4.2.2.4.6.1.2]
b. 9 Apr 1785 d. 3 Dec 1847
Ebenezer Balcom
b. 14 Apr 1783 d. 14 Oct 1836
9
Aaron Balcom
[1.4.2.2.4.6.1.2.1]
b. 1805
9
Joel Chapin Balcom
[1.4.2.2.4.6.1.2.2]
b. Abt 1807
9
Mary Balcom
[1.4.2.2.4.6.1.2.3]
b. Abt 1809
8
Aaron Benson
[1.4.2.2.4.6.1.3]
b. 10 Mar 1788
8
Ellis Benson
[1.4.2.2.4.6.1.4]
b. 13 Oct 1792 d. 31 Mar 1830
8
Lydia Benson
[1.4.2.2.4.6.1.5]
b. 15 Oct 1798
Arnold White
b. 5 Mar 1800
9
Charles White
[1.4.2.2.4.6.1.5.1]
b. 1825 d. 25 Mar 1899
Lucinda M Taft
b. 15 Mar 1826 d. 5 Mar 1906
10
Alice Maria White
[1.4.2.2.4.6.1.5.1.1]
b. 7 May 1865 d. 10 Dec 1892
Everett Burnside Sherman
b. 16 Jun 1862 d. 1935
11
Lillian Maria Sherman
[1.4.2.2.4.6.1.5.1.1.1]
b. 12 Jan 1887
11
Waldo Leonard Sherman
[1.4.2.2.4.6.1.5.1.1.2]
b. 16 Jan 1889 d. 1956
+
Vona Madeline Mellen
b. 1886 d. 1979
11
Evelyn L Sherman
[1.4.2.2.4.6.1.5.1.1.3]
b. 22 Jun 1891
10
Walter Arnold White
[1.4.2.2.4.6.1.5.1.2]
b. 9 May 1869
Ada Mabel Esten
b. 2 Dec 1869
11
Vinton Esten White
[1.4.2.2.4.6.1.5.1.2.1]
b. 26 Jun 1899 d. 11 Mar 2002
+
Ethel Rose Ballou
b. 8 Jun 1892 d. Jan 1975
11
Alton F White
[1.4.2.2.4.6.1.5.1.2.2]
b. 1901
11
Allin Taft White
[1.4.2.2.4.6.1.5.1.2.3]
b. 11 Apr 1901
7
David Benson
[1.4.2.2.4.6.2]
b. 23 Dec 1756 d. 8 Mar 1847
Zilla Marsh
b. 29 Aug 1760 d. 18 Jan 1817
8
Jessie Benson
[1.4.2.2.4.6.2.1]
b. 14 Mar 1781 d. Abt 1846
Olive Wheeler
b. 14 Feb 1788 d. 24 Aug 1846
9
Alanson Benson
[1.4.2.2.4.6.2.1.1]
b. Abt 1807
9
Lyman David Benson
[1.4.2.2.4.6.2.1.2]
b. Abt 1808 d. 1884
9
Susanna Benson
[1.4.2.2.4.6.2.1.3]
b. 1809 d. 9 Jun 1825
9
Laura Benson
[1.4.2.2.4.6.2.1.4]
b. Abt 1809
9
Olive Maria Benson
[1.4.2.2.4.6.2.1.5]
b. 1810 d. 1885
9
L Lavina Benson
[1.4.2.2.4.6.2.1.6]
b. 10 Oct 1810
9
Lanson Wheeler Benson
[1.4.2.2.4.6.2.1.7]
b. 9 Dec 1813
9
Flora Zillah Benson
[1.4.2.2.4.6.2.1.8]
b. 27 Jul 1815 d. 25 Apr 1875
9
Lyman Daniel Benson
[1.4.2.2.4.6.2.1.9]
b. 21 Aug 1817
9
Addison Benson
[1.4.2.2.4.6.2.1.10]
b. 7 May 1822 d. 16 Jul 1873
9
Anderson Benson
[1.4.2.2.4.6.2.1.11]
b. 7 May 1822 d. 1898
8
Betsey Benson
[1.4.2.2.4.6.2.2]
b. 27 Jun 1782
8
Asenath Benson
[1.4.2.2.4.6.2.3]
b. 16 Feb 1784
8
Phineas Benson
[1.4.2.2.4.6.2.4]
b. 31 May 1785 d. 15 Mar 1835
Polly Lucretia Frost
b. 1787 d. 14 May 1864
9
Luman Austin Benson
[1.4.2.2.4.6.2.4.1]
b. 21 Nov 1812
9
Benjamin McClure Benson
[1.4.2.2.4.6.2.4.2]
b. 21 Oct 1816 d. Aug 1858
9
Phineas Benson
[1.4.2.2.4.6.2.4.3]
b. 21 Oct 1816
9
Paulina Lucretia Benson
[1.4.2.2.4.6.2.4.4]
b. 27 May 1820
9
Eliza Ann Benson
[1.4.2.2.4.6.2.4.5]
b. 30 Jan 1823
9
Merrill H Benson
[1.4.2.2.4.6.2.4.6]
b. 14 Feb 1826 d. 25 Dec 1880
8
Levina Benson
[1.4.2.2.4.6.2.5]
b. 6 Sep 1786
8
Cyrus Benson
[1.4.2.2.4.6.2.6]
b. 23 Dec 1787
8
Matilda Benson
[1.4.2.2.4.6.2.7]
b. 10 Apr 1789
8
David Benson
[1.4.2.2.4.6.2.8]
b. 10 Apr 1789 d. 19 Oct 1868
Lucinda Adams
b. 1792 d. 2 Apr 1836
9
Son Benson
[1.4.2.2.4.6.2.8.1]
b. 24 Mar 1818
9
Cyrus Benson
[1.4.2.2.4.6.2.8.2]
b. 15 Feb 1819 d. 1895
9
David E Benson
[1.4.2.2.4.6.2.8.3]
b. 19 Mar 1820 d. 28 Dec 1895
9
Sally A Benson
[1.4.2.2.4.6.2.8.4]
b. 10 Mar 1821 d. 31 Aug 1823
9
Edwin Benson
[1.4.2.2.4.6.2.8.5]
b. 16 Mar 1822 d. 11 Sep 1852
9
Enoch Benson
[1.4.2.2.4.6.2.8.6]
b. 4 May 1823 d. 1901
9
Elliot Benson
[1.4.2.2.4.6.2.8.7]
b. 3 Aug 1824
9
Hannah Benson
[1.4.2.2.4.6.2.8.8]
b. 12 Sep 1825
9
Henry H Benson
[1.4.2.2.4.6.2.8.9]
b. 30 Sep 1827
9
Mary Louisa Benson
[1.4.2.2.4.6.2.8.10]
b. 8 Apr 1830
9
George D Benson
[1.4.2.2.4.6.2.8.11]
b. 18 Nov 1831
9
Merrick C Benson
[1.4.2.2.4.6.2.8.12]
b. 25 Oct 1833 d. Abt 1860
8
Moses Benson
[1.4.2.2.4.6.2.9]
b. 1 Oct 1792
+
Mary Howard
8
Lewis Benson
[1.4.2.2.4.6.2.10]
b. 21 Jan 1794
+
Maria Atwood
b. 6 May 1801
8
Danford Benson
[1.4.2.2.4.6.2.11]
b. 1 Jul 1794 d. 14 Feb 1859
Content Adams
b. 9 Mar 1800 d. 25 Sep 1877
9
Danforth Benson
[1.4.2.2.4.6.2.11.1]
b. 2 Aug 1820 d. 25 Jul 1872
9
Luna Benson
[1.4.2.2.4.6.2.11.2]
b. 10 Jul 1822
9
Lumen P Benson
[1.4.2.2.4.6.2.11.3]
b. 11 Aug 1824
8
Willard Benson
[1.4.2.2.4.6.2.12]
b. 7 Apr 1797
8
Susannah Benson
[1.4.2.2.4.6.2.13]
b. 7 Oct 1798 d. 4 Jan 1817
8
Hannah Azuba Benson
[1.4.2.2.4.6.2.14]
b. 4 Jul 1801
8
Albey Benson
[1.4.2.2.4.6.2.15]
b. 27 Aug 1804
7
Keziah Benson
[1.4.2.2.4.6.3]
b. 1 Mar 1759 d. Abt 1800
7
Daniel Benson
[1.4.2.2.4.6.4]
b. 1 Jun 1761 d. 9 Oct 1854
Phebe Bugbee
b. 1762 d. 3 May 1855
8
Annie Benson
[1.4.2.2.4.6.4.1]
b. 28 Mar 1787
8
Daniel Benson
[1.4.2.2.4.6.4.2]
b. 18 May 1788
8
John Benson
[1.4.2.2.4.6.4.3]
b. 19 Mar 1789
8
Mary Benson
[1.4.2.2.4.6.4.4]
b. 28 May 1791
8
Ebenezer Benson
[1.4.2.2.4.6.4.5]
b. 4 Sep 1793 d. 11 Mar 1870
+
Lucinda
8
Melinda Benson
[1.4.2.2.4.6.4.6]
b. 25 Jul 1795
8
Orrison Benson
[1.4.2.2.4.6.4.7]
b. 31 Aug 1797 d. 24 Apr 1883
+
Mary Williams
b. 1800
8
Sally Benson
[1.4.2.2.4.6.4.8]
b. 30 Jul 1799
John Kneeland
b. Abt 1795
9
Ichabod Kneeland
[1.4.2.2.4.6.4.8.1]
b. Abt 1821
8
Arza Benson
[1.4.2.2.4.6.4.9]
b. 7 Jul 1803
8
James Benson
[1.4.2.2.4.6.4.10]
b. 3 Jan 1805
8
Chester Benson
[1.4.2.2.4.6.4.11]
b. 26 Jan 1807 d. 19 Aug 1889
Florilla Williams
b. 8 Sep 1806 d. 14 Dec 1889
9
Cyntha Elnora Benson
[1.4.2.2.4.6.4.11.1]
b. 3 Oct 1827
9
Ellen Mariah Benson
[1.4.2.2.4.6.4.11.2]
b. 22 Aug 1829
9
Harriet Benson
[1.4.2.2.4.6.4.11.3]
b. 20 Sep 1831
9
Arza Benson
[1.4.2.2.4.6.4.11.4]
b. 13 Jul 1833
9
Walter Williams Benson
[1.4.2.2.4.6.4.11.5]
b. 5 Apr 1835 d. 5 Feb 1905
9
Chester Seldin Benson
[1.4.2.2.4.6.4.11.6]
b. 27 Mar 1837
9
Henry E. Benson
[1.4.2.2.4.6.4.11.7]
b. 6 May 1839
9
Harlon Clinton Benson
[1.4.2.2.4.6.4.11.8]
b. 2 May 1841
9
Meredith Mosell Benson
[1.4.2.2.4.6.4.11.9]
b. 7 Apr 1843
9
Lucy Marion Benson
[1.4.2.2.4.6.4.11.10]
b. 5 Jun 1845 d. 12 Jul 1916
9
Herbert Leslie Benson
[1.4.2.2.4.6.4.11.11]
b. 5 Dec 1847
9
Florilla Ada Benson
[1.4.2.2.4.6.4.11.12]
b. 22 Dec 1851
8
Cynthia Benson
[1.4.2.2.4.6.4.12]
b. 16 Jan 1809
8
Fanny Benson
[1.4.2.2.4.6.4.13]
b. 2 Jun 1811
7
Peter Benson
[1.4.2.2.4.6.5]
b. 16 Jul 1763 d. 23 Mar 1854
7
Jesse Benson
[1.4.2.2.4.6.6]
b. 19 Feb 1766
7
Anna Benson
[1.4.2.2.4.6.7]
b. 6 Aug 1767
7
Hannah Benson
[1.4.2.2.4.6.8]
b. 3 Mar 1770
7
Susanna Benson
[1.4.2.2.4.6.9]
b. 26 Aug 1772
7
Eunice Benson
[1.4.2.2.4.6.10]
b. 4 May 1775
5
Johannah Holbrook
[1.4.2.2.5]
b. 7 Mar 1686
5
Richard Holbrook
[1.4.2.2.6]
b. 30 Mar 1690 d. 1770
Abigail Albee
b. 15 Mar 1701
6
Benjamin Holbrook
[1.4.2.2.6.1]
b. 14 Feb 1723 d. 1757
Abigail Benson
b. 12 Aug 1731 d. 21 Dec 1813
7
Son Holbrook
[1.4.2.2.6.1.1]
b. Abt 1748
7
Abigail Holbrook
[1.4.2.2.6.1.2]
b. 15 Aug 1749
7
Abiah Holbrook
[1.4.2.2.6.1.3]
b. 4 Mar 1752
7
Reuben Holbrook
[1.4.2.2.6.1.4]
b. 18 Jul 1754 d. 1835
Rachel Darling
b. 1 May 1755 d. Bef 1818
8
Abigail Holbrook
[1.4.2.2.6.1.4.1]
b. 8 Jan 1778
8
Rachael Holbrook
[1.4.2.2.6.1.4.2]
b. 8 Jan 1780
Foster Verry
b. 7 Oct 1789 d. 1860
9
Albert Verry
[1.4.2.2.6.1.4.2.1]
b. 15 Jul 1812
9
James Verry
[1.4.2.2.6.1.4.2.2]
b. 27 Feb 1814
Nancy Nolen
10
Ester Jane Verry
[1.4.2.2.6.1.4.2.2.1]
b. 19 Aug 1836 d. 10 Aug 1847
10
Isadore Verry
[1.4.2.2.6.1.4.2.2.2]
b. 10 Jul 1839
Daniel Bullard Pond
b. 23 Oct 1830
11
Verry Nolen Pond
[1.4.2.2.6.1.4.2.2.2.1]
b. 7 Jul 1862 d. 28 Feb 1866
11
Clarence Eli Pond
[1.4.2.2.6.1.4.2.2.2.2]
b. 14 Apr 1864 d. 19 Sep 1865
11
Isadore Maud Pond
[1.4.2.2.6.1.4.2.2.2.3]
b. 11 Sep 1868
11
Nancy May Pond
[1.4.2.2.6.1.4.2.2.2.4]
b. 19 May 1871
9
Chloe Holbrook Verry
[1.4.2.2.6.1.4.2.3]
b. 20 Mar 1816
David Smith Wilder
b. 20 Aug 1813 d. 13 Nov 1898
10
Albert Verry Wilder
[1.4.2.2.6.1.4.2.3.1]
b. 6 Feb 1838 d. Bef 1948
10
Foster Verry Wilder
[1.4.2.2.6.1.4.2.3.2]
b. 16 Apr 1839 d. Bef 1949
10
Abel Wilder
[1.4.2.2.6.1.4.2.3.3]
b. Abt 1840 d. Bef 1845
10
Chloeanna Wilder
[1.4.2.2.6.1.4.2.3.4]
b. Abt 1842 d. Bef 1846
10
Clara Deetta Wilder
[1.4.2.2.6.1.4.2.3.5]
b. Abt 1844 d. Bef 1850
10
Deetta Wilder
[1.4.2.2.6.1.4.2.3.6]
b. Abt 1845 d. Bef 1851
9
Sally Verry
[1.4.2.2.6.1.4.2.4]
b. 30 Apr 1818
9
Foster Verry
[1.4.2.2.6.1.4.2.5]
b. 3 Oct 1821 d. 29 Jun 1837
8
Prudence Holbrook
[1.4.2.2.6.1.4.3]
b. 25 Feb 1782
8
Anna Holbrook
[1.4.2.2.6.1.4.4]
b. 30 Mar 1784 d. 16 Mar 1851
Samuel Fairbanks
b. 8 Apr 1784 d. 22 Jul 1845
9
Samuel Fairbanks
[1.4.2.2.6.1.4.4.1]
b. Feb 1803 d. Aft 1852
9
Hester Fairbanks
[1.4.2.2.6.1.4.4.2]
b. 11 Apr 1804 d. Bef 1825
9
Mary Ann Fairbanks
[1.4.2.2.6.1.4.4.3]
b. 27 Apr 1806 d. 1858
Elhanim Hartwell
b. 1819
10
Eunice Elsie Hartwell
[1.4.2.2.6.1.4.4.3.1]
b. 7 May 1849
John M Proctor
b. 24 Sep 1825 d. 21 Jul 1907
11
Lena Esta Proctor
[1.4.2.2.6.1.4.4.3.1.1]
b. 30 Nov 1874 d. 18 May 1936
Almon Harl Ketchum
b. 14 Mar 1861 d. 9 Jan 1941
12
Ira H Ketchum
[1.4.2.2.6.1.4.4.3.1.1.1]
b. 8 Sep 1898 d. Jan 1972
12
Elsie L Ketchum
[1.4.2.2.6.1.4.4.3.1.1.2]
b. 3 Mar 1903 d. 10 May 2000
11
William Jay Proctor
[1.4.2.2.6.1.4.4.3.1.2]
b. 3 Jan 1881 d. 26 Jan 1921
Minnie May Betts
b. 22 Jan 1888 d. 19 Jul 1959
12
Ruth Proctor
[1.4.2.2.6.1.4.4.3.1.2.1]
b. 1 Apr 1905 d. 26 Jan 1982
12
Grace Proctor
[1.4.2.2.6.1.4.4.3.1.2.2]
b. 13 Dec 1909 d. 22 Oct 2001
12
Frederick Lewis Proctor
[1.4.2.2.6.1.4.4.3.1.2.3]
b. 14 Jul 1911 d. 17 Sep 1912
12
Violet May Proctor
[1.4.2.2.6.1.4.4.3.1.2.4]
b. 10 Feb 1913 d. 2 Mar 1995
12
Roy Alverton Proctor
[1.4.2.2.6.1.4.4.3.1.2.5]
b. 5 Sep 1914 d. 30 Dec 1998
12
Pearl Esther Proctor
[1.4.2.2.6.1.4.4.3.1.2.6]
b. 23 Sep 1919 d. 17 Sep 2000
9
Elizabeth Fairbanks
[1.4.2.2.6.1.4.4.4]
b. 14 Nov 1814 d. 12 Oct 1872
Stewart Smiley
b. Abt 1808 d. 1892
10
William G Smiley
[1.4.2.2.6.1.4.4.4.1]
10
Thomas J Smiley
[1.4.2.2.6.1.4.4.4.2]
10
Charels E Smiley
[1.4.2.2.6.1.4.4.4.3]
10
Stuart Smiley
[1.4.2.2.6.1.4.4.4.4]
10
Adelbert Smiley
[1.4.2.2.6.1.4.4.4.5]
10
Frank B Smiley
[1.4.2.2.6.1.4.4.4.6]
10
Abbie Smiley
[1.4.2.2.6.1.4.4.4.7]
10
George Smiley
[1.4.2.2.6.1.4.4.4.8]
10
Adelia Smiley
[1.4.2.2.6.1.4.4.4.9]
10
Melvina Smiley
[1.4.2.2.6.1.4.4.4.10]
10
Susan Smiley
[1.4.2.2.6.1.4.4.4.11]
10
Mary Ann Smiley
[1.4.2.2.6.1.4.4.4.12]
10
Fredrick Lee Smiley
[1.4.2.2.6.1.4.4.4.13]
b. 23 Oct 1853 d. 17 Jun 1903
Eliza J Metcalf
b. Abt 1860 d. 19 Jul 1926
11
Charles Smiley
[1.4.2.2.6.1.4.4.4.13.1]
b. 1875
11
Earl Ray "Bert" Smiley
[1.4.2.2.6.1.4.4.4.13.2]
b. 1879
11
Mabel Frances Smiley
[1.4.2.2.6.1.4.4.4.13.3]
b. 12 Feb 1884 d. 23 Aug 1953
Phillip Henry Bowen
b. 14 Feb 1875 d. 12 Aug 1942
12
Bonita Magdeline Bowen
[1.4.2.2.6.1.4.4.4.13.3.1]
b. 6 Dec 1901 d. 24 Mar 1992 [
=>
]
12
Helen Neoma Bowen
[1.4.2.2.6.1.4.4.4.13.3.2]
b. 7 Aug 1904 d. 1 May 1946
12
Margaret Elizabeth Bowen
[1.4.2.2.6.1.4.4.4.13.3.3]
b. 15 Aug 1905 d. Bef 2008
12
Ardith Gail Bowen
[1.4.2.2.6.1.4.4.4.13.3.4]
b. 14 Jun 1908 d. 20 Dec 1988
12
Betty Jean Bowen
[1.4.2.2.6.1.4.4.4.13.3.5]
b. 25 Nov 1919 d. 9 May 2001
11
Alice Smiley
[1.4.2.2.6.1.4.4.4.13.4]
b. Dec 1882
11
Clarence Smiley
[1.4.2.2.6.1.4.4.4.13.5]
b. Jun 1889
11
Harold Smiley
[1.4.2.2.6.1.4.4.4.13.6]
b. Jul 1893
9
Benjamin Fairbanks
[1.4.2.2.6.1.4.4.5]
b. 17 Feb 1808 d. 7 Oct 1876
Eunice Mead
b. 14 Jan 1811 d. 20 Aug 1893
10
Frances Adelia Fairbanks
[1.4.2.2.6.1.4.4.5.1]
b. 10 Mar 1832
10
Anna Fairbanks
[1.4.2.2.6.1.4.4.5.2]
b. 7 Sep 1833
10
Esther Fairbanks
[1.4.2.2.6.1.4.4.5.3]
b. 9 Mar 1835
10
Samuel Fairbanks
[1.4.2.2.6.1.4.4.5.4]
b. 21 Mar 1837 d. 27 Sep 1881
Harriet E Rounds
b. 29 Sep 1840
11
Mary Smiley Fairbanks
[1.4.2.2.6.1.4.4.5.4.1]
b. 24 Nov 1862 d. 16 Mar 1870
11
Benjamin Rounds Fairbanks
[1.4.2.2.6.1.4.4.5.4.2]
b. 2 Feb 1865
11
Emmay May Fairbanks
[1.4.2.2.6.1.4.4.5.4.3]
b. 7 Nov 1872
11
Vinnie Lelia Fairbanks
[1.4.2.2.6.1.4.4.5.4.4]
b. 7 Nov 1872
11
Ella Tucker Fairbanks
[1.4.2.2.6.1.4.4.5.4.5]
b. 12 Apr 1881
10
Alfred Fairbanks
[1.4.2.2.6.1.4.4.5.5]
b. 2 Jun 1839 d. 6 May 1864
10
Sarah Melissa Fairbanks
[1.4.2.2.6.1.4.4.5.6]
b. 9 Aug 1843 d. 1921
Alanson Goodenow
b. Mar 1842 d. 1931
11
Chauncey B Goodenow
[1.4.2.2.6.1.4.4.5.6.1]
b. Nov 1869 bur. 1934
+
Bertha L
b. Abt 1873
10
Charles B Fairbanks
[1.4.2.2.6.1.4.4.5.7]
b. 22 Sep 1846
Collena Russell
b. 26 Mar 1843
11
Minnie Bell Fairbanks
[1.4.2.2.6.1.4.4.5.7.1]
b. 2 May 1867
11
Hiram Benjamin Fairbanks
[1.4.2.2.6.1.4.4.5.7.2]
b. 2 Feb 1871
11
Florence Lena Fairbanks
[1.4.2.2.6.1.4.4.5.7.3]
b. 26 Apr 1873
10
James Alonzo Fairbanks
[1.4.2.2.6.1.4.4.5.8]
b. 14 Feb 1849
Sarah Williams
b. 27 Aug 1851
11
Nora E Fairbanks
[1.4.2.2.6.1.4.4.5.8.1]
b. 3 Sep 1869 d. 13 Oct 1869
11
Blanche Estella Fairbanks
[1.4.2.2.6.1.4.4.5.8.2]
b. 6 May 1872
11
Fannie Addessa Fairbanks
[1.4.2.2.6.1.4.4.5.8.3]
b. 2 Apr 1874
11
Mark Roy Fairbanks
[1.4.2.2.6.1.4.4.5.8.4]
b. 1 Nov 1876
+
Grace M Weeks
b. 1879
9
Rachel Fairbanks
[1.4.2.2.6.1.4.4.6]
b. 5 Jan 1810 d. Bef 1825
9
Reuben Fairbanks
[1.4.2.2.6.1.4.4.7]
b. 2 Jun 1811 d. Bef 1825
9
Abbie Fairbanks
[1.4.2.2.6.1.4.4.8]
b. Abt 1816
9
Charles Fairbanks
[1.4.2.2.6.1.4.4.9]
b. 9 Mar 1817 d. 22 Oct 1869
Hanna Smith
b. Abt 1829
10
Delilah Fairbanks
[1.4.2.2.6.1.4.4.9.1]
b. 1839
10
Esther Fairbanks
[1.4.2.2.6.1.4.4.9.2]
b. 15 Dec 1841 d. 4 May 1912
10
Orlando Fairbanks
[1.4.2.2.6.1.4.4.9.3]
b. 28 Dec 1842 d. 13 Feb 1871
10
Samuel Fairbanks
[1.4.2.2.6.1.4.4.9.4]
b. 1844 d. 19 Feb 1923
10
Alice J Fairbanks
[1.4.2.2.6.1.4.4.9.5]
b. 14 Apr 1847 d. 14 Feb 1897
Martin H Kilborn
b. 22 Feb 1845 d. 17 Dec 1910
11
Anna Belle Kilborn
[1.4.2.2.6.1.4.4.9.5.1]
b. 22 Sep 1867 d. 11 Feb 1955
Hiram B Burroughs
b. 25 Nov 1864 d. 17 Apr 1909
12
Paul K Burroughs
[1.4.2.2.6.1.4.4.9.5.1.1]
b. 16 May 1888 d. 10 Mar 1904
12
Joe O Burroughs
[1.4.2.2.6.1.4.4.9.5.1.2]
b. 14 Jun 1895 d. 20 Dec 1968 [
=>
]
+
James Ellery Holcomb
b. 23 Mar 1871 d. 23 Jan 1943
11
Etta J Kilborn
[1.4.2.2.6.1.4.4.9.5.2]
b. 22 Apr 1869 d. 5 Nov 1870
11
Myrtie L Kilborn
[1.4.2.2.6.1.4.4.9.5.3]
b. 21 Aug 1875 d. 25 Dec 1924
Martin L Burroughs
b. Mar 1870 d. 18 Mar 1899
12
Mary Alice Burroughs
[1.4.2.2.6.1.4.4.9.5.3.1]
b. 3 May 1896 d. 4 Mar 1908
William Griffin
b. Abt 1871 d. 1920
12
Emily Griffin
[1.4.2.2.6.1.4.4.9.5.3.2]
b. 29 Mar 1902 d. 1980
11
Leonora May Kilborn
[1.4.2.2.6.1.4.4.9.5.4]
b. 23 May 1883
11
Nellie M Kilborn
[1.4.2.2.6.1.4.4.9.5.5]
b. 23 May 1883 d. 26 Feb 1945
John Leland Clark
b. 26 Jan 1880 d. 11 May 1945
12
Paul Kilborn Clark
[1.4.2.2.6.1.4.4.9.5.5.1]
b. 5 Jul 1905 d. 30 Dec 1984 [
=>
]
10
Benjamin Fairbanks
[1.4.2.2.6.1.4.4.9.6]
b. 3 Dec 1848 d. 3 Feb 1925
10
Abbey D Fairbanks
[1.4.2.2.6.1.4.4.9.7]
b. 4 Feb 1851 d. 4 Nov 1860
10
Sibyl Fairbanks
[1.4.2.2.6.1.4.4.9.8]
b. 30 Jun 1852 d. 30 Aug 1852
10
Libbie Fairbanks
[1.4.2.2.6.1.4.4.9.9]
b. 1856
10
Addie Fairbanks
[1.4.2.2.6.1.4.4.9.10]
10
Lee Fairbanks
[1.4.2.2.6.1.4.4.9.11]
9
Abigail C Fairbanks
[1.4.2.2.6.1.4.4.10]
b. 11 Aug 1825 d. 30 Jun 1848
David R Garrison
b. 1824 d. 1898
10
Mary Garrison
[1.4.2.2.6.1.4.4.10.1]
b. 1844 d. 1876
10
Cornelius Garrison
[1.4.2.2.6.1.4.4.10.2]
b. Abt 1849 d. 1928
10
Annie Garrison
[1.4.2.2.6.1.4.4.10.3]
b. 1853
10
Sarah Ellen Garrison
[1.4.2.2.6.1.4.4.10.4]
b. 31 Mar 1856
10
Willie Garrison
[1.4.2.2.6.1.4.4.10.5]
b. 1858
10
Bennie Garrison
[1.4.2.2.6.1.4.4.10.6]
b. 1860
10
Frank L Garrison
[1.4.2.2.6.1.4.4.10.7]
b. 25 May 1862
10
Georgianne Garrison
[1.4.2.2.6.1.4.4.10.8]
b. 11 Oct 1869
Horace B Andrews
b. 31 Oct 1866
11
Ether Andrews
[1.4.2.2.6.1.4.4.10.8.1]
b. 3 Mar 1894
8
Benjamin Holbrook
[1.4.2.2.6.1.4.5]
b. 31 Jan 1786
6
Abial Holbrook
[1.4.2.2.6.2]
b. 30 Jun 1724
6
Richard Holbrook
[1.4.2.2.6.3]
b. 7 Feb 1726 d. Abt 1770
6
Susanna Holbrook
[1.4.2.2.6.4]
b. 15 Jan 1730 d. 15 Jan 1730
6
Thankful Holbrook
[1.4.2.2.6.5]
b. 24 Oct 1731
6
Peter Holbrook
[1.4.2.2.6.6]
b. 23 Jan 1735
5
Eliphalet Holbrook
[1.4.2.2.7]
b. 27 Jan 1691 d. 19 Oct 1775
5
William Holbrook
[1.4.2.2.8]
b. 28 Mar 1693
5
Samuel Holbrook
[1.4.2.2.9]
b. 27 Feb 1695
5
Thomas Holbrook
[1.4.2.2.10]
b. Abt 1698 d. 15 Aug 1702
5
Mary Holbrook
[1.4.2.2.11]
b. 14 Oct 1702 d. 4 Mar 1781
4
Joanna Holbrook
[1.4.2.3]
b. 30 May 1657 d. 1 Mar 1682
4
Thomas Holbrook
[1.4.2.4]
b. 15 Oct 1653 d. 20 Dec 1728
4
Joseph Holbrook
[1.4.2.5]
b. 10 Apr 1660
4
Mary Holbrook
[1.4.2.6]
b. 1663 d. Feb 1738
4
Susannah Holbrook
[1.4.2.7]
b. 1665
3
Anne Kingman
[1.4.3]
b. Abt 1625 d. 1704
3
Thomas Kingman
[1.4.4]
b. 1628 d. 1705
3
John Kingman
[1.4.5]
b. Abt 1633 d. 9 Dec 1690
Elizabeth Edson
b. Abt 1643 d. Abt 1695
4
John Kingman
[1.4.5.1]
b. 20 Apr 1664 d. 8 Jan 1755
4
Henry Kingman
[1.4.5.2]
b. 11 May 1668 bur. 21 Oct 1738
4
Samuel Kingman
[1.4.5.3]
b. 29 Apr 1670 d. 20 May 1742
Mary Michell
b. 1 Jan 1674 d. 1710
5
Susanna Kingman
[1.4.5.3.1]
b. 12 Apr 1697 d. Bef 1760
5
John KIngman
[1.4.5.3.2]
b. 4 Jun 1699 d. 11 Apr 1775
5
Joanna Kingman
[1.4.5.3.3]
b. 7 May 1701 d. 1742
Ackerman Pettingill
b. 30 Jun 1700 d. 1770
6
Nathan Pettingill
[1.4.5.3.3.1]
b. 28 May 1724
6
Daniel Pettingill
[1.4.5.3.3.2]
b. 10 Oct 1726 d. 20 Nov 1808
6
Hannah Pettingill
[1.4.5.3.3.3]
b. Abt 1728 d. 28 Jul 1799
David Soloman Avery
b. 22 Oct 1719 d. Sep 1791
7
Joanna Avery
[1.4.5.3.3.3.1]
b. 27 Jun 1747
7
Mehetable Avery
[1.4.5.3.3.3.2]
b. 20 Jun 1749
7
Thomas Avery
[1.4.5.3.3.3.3]
b. 3 Nov 1751
7
Dr Jonathan Avery
[1.4.5.3.3.3.4]
b. 8 Apr 1756 d. 1835
7
Jacob Avery
[1.4.5.3.3.3.5]
b. 9 Sep 1758
7
Ebenezer Avery
[1.4.5.3.3.3.6]
b. 13 Mar 1762 d. 10 Dec 1839
7
Polly Avery
[1.4.5.3.3.3.7]
b. 31 Mar 1763 d. 1828
Edmond Curtis
b. 27 Feb 1763 d. 17 Sep 1814
8
Enos Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1]
b. 9 Oct 1783 d. 1 Jun 1856
Ruth Franklin
b. 14 Nov 1790 d. 6 May 1848
9
Lydia Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.1]
b. 5 Feb 1808 d. 5 Jul 1809
9
Maria Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.2]
b. 22 Mar 1810 d. 5 May 1841
9
Martha Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.3]
b. 12 Aug 1812 d. 22 Dec 1834
9
Edmond Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.4]
b. 5 Nov 1814 d. 6 Jan 1815
9
Jeremiah Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.5]
b. 12 Nov 1815 d. 22 Feb 1816
9
Seth Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.6]
b. 8 Mar 1817 d. 8 Mar 1817
9
Simmons Philander Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.7]
b. 26 Mar 1818 d. 11 Apr 1880
9
David Avery Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.8]
b. 10 Aug 1820 d. 5 Oct 1885
9
John White Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.9]
b. 11 Aug 1820 d. 7 Oct 1902
9
Ezra Houghton Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.10]
b. 19 Feb 1823 d. 28 Aug 1915
Lucinda McKenney Carter
b. 14 Jan 1831 d. 26 Jan 1904
10
Lydia Ann Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.1]
b. 20 Sep 1848 d. 29 Aug 1862
10
Melissa Jane Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.2]
b. 25 Jul 1850 d. 21 Oct 1923
10
Arletta Adelia Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.3]
b. 25 May 1852 d. 7 May 1895
William Jenkins
b. 2 Jun 1841 d. 28 Jan 1931
11
Arletta Jenkins
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.3.1]
b. 1 Dec 1870 d. 18 Mar 1945
11
William Jenkins
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.3.2]
b. 17 Sep 1873 d. 26 Dec 1947
11
Margaret Lucinda Jenkins
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.3.3]
b. 13 Sep 1876 d. 16 Apr 1938
11
Olive Elizabeth Jenkins
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.3.4]
b. 6 Oct 1878 d. 18 Apr 1962
11
Isabell Jenkins
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.3.5]
b. 24 Apr 1881 d. 15 Jun 1966
11
Mabel Jenkins
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.3.6]
b. 24 Apr 1881 d. 21 Oct 1962
11
Ruth Ann Jenkins
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.3.7]
b. 19 Dec 1883 d. 15 Dec 1958
11
Clara Amelia Jenkins
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.3.8]
b. 10 Oct 1887 d. 28 Jun 1965
Alvin James Christensen
b. 16 Aug 1886 d. 26 Apr 1917
12
Phyllis Christensen
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.3.8.1]
b. 3 Mar 1910 d. 26 Feb 2004
12
Gisford Jenkins Christensen
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.3.8.2]
b. 8 Aug 1911 d. 2 May 1953
12
Georgia Rose Christensen
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.3.8.3]
b. 13 Jun 1913 d. 16 Oct 1977
12
Rhoda Christensen
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.3.8.4]
b. 23 Jan 1915 d. 11 Feb 2008 [
=>
]
12
Richard Christensen
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.3.8.5]
b. 26 Apr 1916 d. 26 Apr 1916
11
Chloe Adelia Jenkins
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.3.9]
b. 10 Oct 1887 d. 12 Jul 1928
10
Ezra Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.4]
b. 13 Aug 1854 d. 24 Feb 1925
Mary Ann Whipple
b. 4 Mar 1859 d. 23 May 1919
11
Dagbert Edson Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.4.1]
b. 27 May 1878 d. 6 Dec 1883
11
William Ezra Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.4.2]
b. 14 Jul 1880 d. 22 Aug 1935
Grace Chloe Lake
b. 6 Jul 1889 d. 14 Jun 1951
12
Verda Grace Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.4.2.1]
b. 10 Feb 1909 d. 5 Jun 1929 [
=>
]
12
Merrill William Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.4.2.2]
b. 5 Oct 1910 d. 25 May 1995 [
=>
]
12
Loreta Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.4.2.3]
b. 24 Jan 1913 d. 1 Feb 1913
12
Tressie Ellen Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.4.2.4]
b. 24 Jul 1914 d. 4 Apr 2001 [
=>
]
12
Arta Lillie Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.4.2.5]
b. 28 May 1915 d. 31 Oct 1995 [
=>
]
12
Doyle Willis Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.4.2.6]
b. 26 May 1918 d. 18 Aug 2004 [
=>
]
12
Rita Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.4.2.7]
b. 3 Mar 1920 d. 28 Apr 1986 [
=>
]
12
LaVee Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.4.2.8]
b. 6 Jul 1922 d. 24 Apr 2008
12
BerLee Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.4.2.9]
b. 16 May 1924 d. 26 Jan 2013
12
Shirley LaRay Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.4.2.10]
b. 8 Jul 1927 d. 9 Oct 2010
11
Willis Sidney Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.4.3]
b. 14 Jul 1880 d. 13 Jul 1918
11
LeRoy Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.4.4]
b. 25 Oct 1882
11
Adelia Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.4.5]
b. 9 Feb 1885 d. 27 Jun 1898
11
Blanche Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.4.6]
b. 19 Aug 1887 d. 28 Jul 1978
Warren Jones
b. 7 May 1881 d. 14 Jun 1917
12
Rubie Adelia Jones
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.4.6.1]
b. 11 Sep 1907 d. 29 Aug 1988
12
Warren LeRoy Jones
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.4.6.2]
b. 28 Dec 1909 d. 9 Dec 1993
+
Oley Larsen
b. 1892
11
Sterling Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.4.7]
b. 10 Jan 1890 d. 3 Sep 1954
Myrtle Emily Lake
b. 30 Jul 1900 d. 7 Mar 1984
12
Rhoda Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.4.7.1]
b. 7 Mar 1920 d. 8 Mar 1920
12
Sterling Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.4.7.2]
b. 19 Nov 1920 d. 19 Nov 1920
12
Ruben Duane Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.4.7.3]
b. 28 Jan 1922 d. 21 Nov 2002
12
Buddie Roland Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.4.7.4]
b. 5 May 1924 d. 19 Jun 2004
12
Ed LeRoy Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.4.7.5]
b. 24 Nov 1928 d. 17 Jan 1966 [
=>
]
12
Ted E Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.4.7.6]
b. 23 Apr 1937 d. 21 Mar 2012
11
Martha Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.4.8]
b. 27 Mar 1892 d. 19 Oct 1980
Daniel Sinclair Stevenson
b. 10 Apr 1892 d. 9 Jul 1957
12
Ruth Irene Stevenson
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.4.8.1]
b. 22 Apr 1913 d. 6 Nov 2001 [
=>
]
12
Mary Ann Jenavee Stevenson
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.4.8.2]
b. 1 Jun 1915 d. 31 Mar 2004
12
Daniel Ezra Stevenson
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.4.8.3]
b. 1 Apr 1918 d. 27 Dec 1975
12
Keith Leroy Stevenson
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.4.8.4]
b. 20 Dec 1923 d. 28 Jun 1997 [
=>
]
12
Curtis Leon Stevenson
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.4.8.5]
b. 24 Aug 1925 d. 14 Oct 1979 [
=>
]
12
Betty Myrleen Stevenson
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.4.8.6]
b. 6 Aug 1933 d. 29 Dec 1988
11
Lavinia Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.4.9]
b. 20 Dec 1893 d. 26 Apr 1979
+
Alfred Earl Hadden
b. 15 Oct 1884 d. 9 Jun 1968
Vernon J Binder
b. 1900
12
Helen Joan Binder
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.4.9.1]
b. 30 Mar 1930 d. 18 Feb 1999
+
Don Young
b. Abt 1890
+
Edward Abel
b. Abt 1890
11
Carter Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.4.10]
b. 10 Jan 1897 d. 1 Dec 1918
+
Jane D
b. Abt 1898
11
Orson Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.4.11]
b. 27 Sep 1899 d. 31 May 1979
+
Mary Margaret Brakefield
b. 2 Dec 1897 d. 8 Nov 1981
11
Lealeth Mildred Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.4.12]
b. 16 Mar 1903 d. 6 Apr 1954
William Basil Gibson
b. 27 Jun 1901 d. 14 Jan 1973
12
William Curtis Gibson
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.4.12.1]
b. 16 Mar 1939 d. 18 Apr 1959
10
Olive Lucinda Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.5]
b. 30 Oct 1856 d. 15 Jan 1937
10
Sidney Amos Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.6]
b. 15 Jan 1859 d. 27 Feb 1925
10
Lorenzo Snow Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.7]
b. 5 Nov 1861 d. 2 Nov 1927
10
Hannah Eliza Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.8]
b. 2 Feb 1864 d. 2 Feb 1864
10
Laura Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.9]
b. 23 Oct 1865 d. 23 Oct 1865
10
Isabell Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.10]
b. 31 Dec 1866 d. 17 Dec 1951
10
Ruth Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.11]
b. 4 Mar 1870 d. 8 Jan 1941
Harry M Payne
b. 3 Dec 1857 d. 28 Feb 1940
11
Edna Payne
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.11.1]
b. 15 Jun 1887 d. 2 Mar 1957
11
Lucinda Payne
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.11.2]
b. 12 Feb 1892 d. 23 Apr 1977
11
Ezra Curtis "Ted" Payne
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.11.3]
b. 3 Mar 1894 d. 29 Jan 1964
11
Emma Belle Payne
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.11.4]
b. 18 Mar 1896 d. 2 Dec 1986
11
Bessie Payne
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.11.5]
b. 19 Oct 1898 d. 3 Aug 1900
11
Wilford Houghton Payne
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.11.6]
b. 3 Apr 1901 d. 1 Dec 1982
11
Ila Payne
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.11.7]
b. 3 Jan 1904 d. 17 Feb 1905
11
Ivan Carter Payne
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.11.8]
b. 4 Dec 1905 d. 12 May 1988
11
Harry Vearle Payne
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.11.9]
b. 6 Sep 1908 d. 20 Jul 1984
11
Roy Arnold Payne
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.11.10]
b. 4 Apr 1914 d. 11 Jan 1997
10
Wilford Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.10.12]
b. 27 May 1874 d. 16 Sep 1938
9
Ruth Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.11]
b. 4 Jun 1825 d. 4 Oct 1825
9
Ursula Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.12]
b. 14 Dec 1826 d. 20 Jun 1902
9
Sabrina Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.13]
b. 3 Apr 1829 d. 27 Jun 1890
George Elisha King
b. 23 Oct 1828 d. 28 Oct 1855
10
David Abraham King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1]
b. 21 Jan 1847 d. 18 Mar 1921
Anna Hannah Hicks
b. 8 Sep 1849 d. 9 Jun 1894
11
David Smith King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.1]
b. 28 May 1867 d. 25 Aug 1941
Mary Hannah Thornton
b. 18 Nov 1861 d. 8 Dec 1920
12
Lydia Hilda King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.1.1]
b. 18 Nov 1885 d. 13 Feb 1950 [
=>
]
12
Elsie Serena King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.1.2]
b. 8 Dec 1887 d. 27 May 1919 [
=>
]
12
David William King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.1.3]
b. 14 Jan 1890 d. 30 Aug 1968 [
=>
]
12
Ellman King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.1.4]
b. 28 May 1892 d. 26 Apr 1972 [
=>
]
12
Clarence King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.1.5]
b. 8 Dec 1894 d. 3 Nov 1946 [
=>
]
12
Lorenzo Smith King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.1.6]
b. 14 Mar 1895 d. 28 Jun 1968 [
=>
]
12
Lloyd Franklin King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.1.7]
b. 28 Nov 1897 d. 7 Nov 1945 [
=>
]
12
Detta Maud King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.1.8]
b. 13 Sep 1898 d. 25 Nov 1971 [
=>
]
12
Mary Ellen King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.1.9]
b. 27 Nov 1900 d. 22 Nov 1978 [
=>
]
11
Anna Larcena King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.2]
b. 23 Oct 1868 d. 2 Aug 1944
Henry Jackson Russell
b. 5 Apr 1869 d. 19 Feb 1935
12
Annie Viola Russell
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.2.1]
b. 9 Oct 1889 d. 23 Sep 1944 [
=>
]
12
Athus Jackson Russell
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.2.2]
b. 29 Dec 1894 d. 29 Mar 1931 [
=>
]
12
Maudie Russell
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.2.3]
b. 16 Feb 1897 d. 11 Oct 1910
12
Ruby Russell
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.2.4]
b. 28 Dec 1899 d. 15 Jul 1928 [
=>
]
12
Edwin Russell
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.2.5]
b. 23 Feb 1902 d. 15 Jul 1928
11
William Henry King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.3]
b. 14 Oct 1870 d. 27 Feb 1957
Martha Celinda Russell
b. 17 Dec 1870 d. 25 Jul 1956
12
Celinda Rosalie King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.3.1]
b. 27 Jul 1889 d. 24 Oct 1890
12
William Rule King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.3.2]
b. 20 Jun 1891 d. 2 Dec 1914 [
=>
]
12
Byrd Calvin King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.3.3]
b. 7 Jun 1893 d. 22 Mar 1900
12
Stanley Ervin King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.3.4]
b. 7 May 1895 d. 10 Jan 1984 [
=>
]
12
Owen Clarence King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.3.5]
b. 22 May 1897 d. 20 Jul 1965 [
=>
]
12
Lillie May King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.3.6]
b. 15 Oct 1899 d. 28 Aug 1942 [
=>
]
12
Ruby Irene King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.3.7]
b. 12 Oct 1901 d. 20 Nov 1989 [
=>
]
12
Nellie Florence King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.3.8]
b. 13 Jun 1904 d. 23 Jul 1991 [
=>
]
12
Ruben R King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.3.9]
b. 9 Dec 1906 d. 11 Dec 1976 [
=>
]
12
Ivan King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.3.10]
b. 1908 d. 1908
12
Son King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.3.11]
b. Feb 1909 d. Feb 1909
12
Clara Venola King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.3.12]
b. 27 Jan 1911 d. 6 Jul 1987 [
=>
]
12
Blanche Helen King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.3.13]
b. 30 Jan 1913 d. 8 Aug 1985 [
=>
]
12
Living
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.3.14]
12
Son King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.3.15]
b. 1917 d. 1917
11
George King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.4]
b. 7 Apr 1875 d. 26 Dec 1954
Mary Jane Madsen
b. 18 Feb 1881 d. 1 Apr 1963
12
George William King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.4.1]
b. 11 Feb 1900 d. 30 Aug 1975 [
=>
]
12
Lillia Jane King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.4.2]
b. 19 Apr 1902 d. 25 Oct 1951
12
Walter Dewain King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.4.3]
b. 27 Mar 1904 d. 8 Nov 1904
12
Barbara Idella King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.4.4]
b. 21 Sep 1905 d. 14 Mar 1980 [
=>
]
12
Darla Maivis King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.4.5]
b. 14 Feb 1908 d. 5 May 1997 [
=>
]
12
David Renaldo King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.4.6]
b. 2 Nov 1910 d. 25 Oct 1951
12
Lottie Cyrena King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.4.7]
b. 2 Feb 1913 d. 1 Feb 1975
12
Melba Celestia King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.4.8]
b. 17 Dec 1917 d. 10 Jul 1996 [
=>
]
12
Debra Rebecca King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.4.9]
b. 18 Dec 1919 d. 3 Feb 1923
12
Stirling Forest King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.4.10]
b. 29 Jan 1923 d. 12 Jan 1999
12
Bud Ray King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.4.11]
b. 16 Jul 1925 d. 1 Apr 1986 [
=>
]
11
Sarah Elizabeth King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.5]
b. 28 Mar 1877 d. 26 Feb 1881
11
Celestia Ann King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.6]
b. 20 Apr 1879 d. 6 May 1970
Peter Alfred Peterson
b. 30 Sep 1876 d. 7 Mar 1944
12
Alfred Duane Peterson
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.6.1]
b. 11 Sep 1897 d. 12 Aug 1972 [
=>
]
12
Thelma Celestia Peterson
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.6.2]
b. 9 Nov 1899 d. 15 Mar 1986 [
=>
]
12
Myrtle Viola Peterson
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.6.3]
b. 13 Nov 1901 d. 28 Sep 1979 [
=>
]
12
Ila Fay Peterson
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.6.4]
b. 1 Feb 1912 d. 26 Feb 1979
12
John William Peterson
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.6.5]
b. 2 Oct 1917 d. 24 Apr 1979
11
Rebecca Angelina King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.7]
b. 29 Mar 1881 d. 8 Aug 1913
John Louis Downard
b. 6 Sep 1869 d. 23 Sep 1944
12
Manual Louis Downard
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.7.1]
b. 5 Sep 1897 d. 3 Feb 1973 [
=>
]
12
Walter William Downard
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.7.2]
b. 3 Apr 1899 d. 9 Feb 1975 [
=>
]
12
Angelina Downard
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.7.3]
b. Jul 1913
11
Son King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.8]
b. 1883 bur. 1883
11
Lydia King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.9]
b. 16 Oct 1884 d. 15 Nov 1978
Joseph Smith Bird
b. 19 Feb 1880 d. 19 Jan 1949
12
Joseph Edwin Bird
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.9.1]
b. 29 Jan 1901 d. 9 Jun 1984 [
=>
]
12
Anna Maraby Bird
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.9.2]
b. 6 Aug 1903 d. 20 Jan 1984 [
=>
]
12
Parley Duane Bird
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.9.3]
b. 2 Feb 1906 d. 31 Dec 1992 [
=>
]
12
Walter Dee Bird
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.9.4]
b. 11 Apr 1908 d. 11 Sep 1992 [
=>
]
12
Byard Kelsey Bird
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.9.5]
b. 9 Sep 1914 d. 17 Nov 2002 [
=>
]
11
Silas Milo King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.10]
b. 5 Dec 1886 d. 1 Apr 1965
Rosetta Nielsen
b. 7 Nov 1887 d. Aft 1913
12
Martha Rosella King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.10.1]
b. 10 Feb 1910 d. 23 Mar 1987
12
Treasure Alretta King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.10.2]
b. 2 Jun 1911 d. 14 Jun 1981
12
Silas David King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.10.3]
b. 10 Apr 1913 d. 1 Jan 1981
11
Forrest Fountain King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.11]
b. 6 Jan 1889 d. 30 Oct 1956
Mary Celesta Lee
b. 13 Jul 1894 d. 12 Jul 1947
12
Fountain Leroy King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.11.1]
b. 27 Sep 1914 d. 10 Nov 1987 [
=>
]
12
Leon David King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.11.2]
b. 20 Jan 1916 d. 17 Sep 1994 [
=>
]
12
Mary Lovina King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.11.3]
b. 27 Aug 1917 d. 28 Aug 1936
12
Quinton Roosevelt King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.11.4]
b. 28 Mar 1919 d. 25 Nov 1973 [
=>
]
12
Teddy Lee King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.11.5]
b. 26 Dec 1920 d. Nov 1984
12
Max Lee King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.11.6]
b. 1 Nov 1925 d. 10 Jun 2011
12
Claire Gilbert King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.11.7]
b. 6 Oct 1927 d. 8 Aug 2003
12
Don Carlos King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.11.8]
b. 5 Jan 1930 d. 30 May 2003
+
LaVina Maybell Robinson
b. 19 Jun 1909 d. 3 Jan 1960
11
Walter King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.1.12]
b. 9 Mar 1892 d. 28 May 1902
10
Rebecca Angeline King
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.2]
b. 1849 d. 1849
Thomas Harward
b. 6 Feb 1826 d. 26 Dec 1901
10
Thomas Franklin Harward
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.3]
b. 5 Feb 1852 d. 18 May 1854
10
William Henry Harward
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.4]
b. 29 Jan 1854 d. 19 Feb 1936
10
Sarah Ellen Harward
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.5]
b. 11 Jun 1856 d. 3 Sep 1933
10
Celestia Ann Harward
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.6]
b. 13 Mar 1858 d. 9 Mar 1911
10
Sabrina Eliza Harward
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.7]
b. 25 Jun 1860 d. 8 Oct 1944
William Ezra Mason
b. 22 Dec 1852 d. 18 May 1934
11
William Ezra Mason, Jr
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.7.1]
b. 20 Dec 1878 d. 13 Nov 1961
11
Philip Mason
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.7.2]
b. 11 Mar 1880 d. 21 May 1966
Maria Sorensen
b. 24 Sep 1884 d. 7 Oct 1965
12
Vonda Mason
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.7.2.1]
b. 29 Nov 1906 d. 22 Mar 1909
12
Deon Mason
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.7.2.2]
b. 13 Oct 1908 d. 24 Apr 1909
12
Philip Grant Mason
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.7.2.3]
b. 29 Mar 1910 d. 9 Sep 1994
12
Wendell Mason
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.7.2.4]
b. 3 Jun 1912 d. 17 Jun 1912
12
Orland E Mason
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.7.2.5]
b. 10 Apr 1913 d. 25 May 2005
12
Laun H Mason
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.7.2.6]
b. 1 Mar 1915 d. 24 May 1992
12
Helen Mason
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.7.2.7]
b. 1 Aug 1917 d. 11 Oct 2006
12
Iza Leaola Mason
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.7.2.8]
b. 14 Nov 1919 d. 17 May 1921
12
Verr Don Mason
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.7.2.9]
b. 4 May 1922 d. 31 Dec 2011
12
Betty Lou Mason
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.7.2.10]
b. 10 May 1926 d. 5 Oct 2003
12
Beverly Mason
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.7.2.11]
b. 16 May 1930 d. 21 Jan 2011
11
Luella Mason
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.7.3]
b. 19 Mar 1882 d. 18 Feb 1968
11
Sabrina Eliza Mason
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.7.4]
b. 27 Jul 1884 d. 29 Apr 1953
George Lynn Holdaway
b. 25 Oct 1881 d. 23 Jan 1939
12
Aretta Holdaway
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.7.4.1]
b. 3 Jan 1904 d. 23 Nov 1978 [
=>
]
12
Ireta Holdaway
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.7.4.2]
b. 3 Jan 1904 d. 20 Jan 1952 [
=>
]
12
Lyndon Holdaway
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.7.4.3]
b. 27 Jan 1906 d. 24 Dec 1908
12
Royal Lynn Holdaway
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.7.4.4]
b. 26 Dec 1909 d. 16 Feb 1994 [
=>
]
12
Tressa Holdaway
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.7.4.5]
b. 11 Feb 1912 d. 24 Mar 1932
12
Tora Dorthy Holdaway
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.7.4.6]
b. 7 Oct 1914 d. 31 Oct 1994 [
=>
]
12
Larsell Holdaway
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.7.4.7]
b. 17 Feb 1917 d. 16 Sep 1934
12
Allen H Holdaway
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.7.4.8]
b. 13 Jul 1919 d. 2 Mar 1936
11
Cora Charman Mason
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.7.5]
b. 17 Aug 1886 d. 17 Jan 1888
11
Raymond Mason
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.7.6]
b. 30 Sep 1888 d. 11 Jan 1972
11
Ralph Mason
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.7.7]
b. 26 Jan 1891 d. 7 Oct 1983
11
Aldon Mason
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.7.8]
b. 9 Apr 1893 d. 29 Oct 1968
11
Ruth Mabel Mason
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.7.9]
b. 1 Oct 1895 d. 27 Nov 1994
11
George Dewey Mason
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.7.10]
b. 27 Apr 1898 d. 18 Feb 1938
11
Vilda Mason
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.7.11]
b. 17 Sep 1905 d. 5 Dec 1990
10
Ozias Strong Harward
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.8]
b. 13 Nov 1862 d. 7 Jun 1917
10
Heber Harward
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.9]
b. 5 Aug 1865 d. 25 May 1925
10
Mary Alfretta Harward
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.10]
b. 30 Jun 1868 d. 15 Apr 1934
10
Serilla Jane Harward
[1.4.5.3.3.3.7.1.13.11]
b. 13 Sep 1870 d. 11 Apr 1898
9
Celestia Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.1.14]
b. 21 Apr 1832 d. 17 Jun 1891
8
Clarissa Curtis
[1.4.5.3.3.3.7.2]
b. 1788 d. 8 Nov 1844
Peleg Ewell
b. 2 Mar 1782 d. 1866
9
Philander Ewell
[1.4.5.3.3.3.7.2.1]
b. 3 Mar 1809 d. 17 Aug 1895
9
Thomas J Ewell
[1.4.5.3.3.3.7.2.2]
b. 23 Oct 1810 d. Sep 1876
9
Lebeus Ewell
[1.4.5.3.3.3.7.2.3]
b. 12 Sep 1812
9
Avelina Ewell
[1.4.5.3.3.3.7.2.4]
b. 1 Jan 1815 d. 10 Dec 1843
9
Edmond Cole Ewell
[1.4.5.3.3.3.7.2.5]
b. 7 May 1817 d. 20 Oct 1907
9
Marian Ewell
[1.4.5.3.3.3.7.2.6]
b. 10 Oct 1819 d. 6 Feb 1827
9
Irena Ewell
[1.4.5.3.3.3.7.2.7]
b. 17 Dec 1821 d. 20 Aug 1906
9
Peleg Dilloway F Ewell
[1.4.5.3.3.3.7.2.8]
b. 28 Mar 1824 d. 27 Dec 1887
9
Mabel Ewell
[1.4.5.3.3.3.7.2.9]
b. 8 May 1826 d. 23 Nov 1893
9
Luther J Ewell
[1.4.5.3.3.3.7.2.10]
b. 5 Oct 1828 d. 11 Aug 1898
9
Clarissa A Ewell
[1.4.5.3.3.3.7.2.11]
b. 30 Mar 1831 d. 9 Jul 1899
9
Sarah Ewell
[1.4.5.3.3.3.7.2.12]
b. Abt 1833
6
Mathew Pettingill
[1.4.5.3.3.4]
b. 1732
6
Jacob Pettingill
[1.4.5.3.3.5]
b. 1734 d. Aft 1780
6
Stephen Pettingill
[1.4.5.3.3.6]
b. Abt 1740 d. Aft 1790
6
Silence Pettingill
[1.4.5.3.3.7]
b. 9 Feb 1744
5
Jane Kingman
[1.4.5.3.4]
b. 3 Jul 1704 d. 1769
5
Mary Kingman
[1.4.5.3.5]
b. 1706
5
Samuel Kingman
[1.4.5.3.6]
b. 1710 d. 17 Apr 1740
4
Elizabeth Kingman
[1.4.5.4]
b. 9 Jul 1673 d. 1 Mar 1744
Thomas Curry Mitchell
b. 1674 d. 1 Sep 1727
5
Thomas Mitchell
[1.4.5.4.1]
b. 22 Sep 1696 d. Abt 1697
5
Henry Mitchell
[1.4.5.4.2]
b. 25 Aug 1698 d. 6 Apr 1712
5
Timothy Mitchell
[1.4.5.4.3]
b. 7 Dec 1700 d. 30 Sep 1733
5
Susanna Mitchell
[1.4.5.4.4]
b. 10 Feb 1702 d. 20 Jun 1756
Joseph Packard
b. Abt 1698 d. 1760
6
Joseph Packard
[1.4.5.4.4.1]
b. 30 May 1725 d. 28 Jan 1815
6
Parnell Packard
[1.4.5.4.4.2]
b. Abt 1726 d. 24 Dec 1804
David Johnson
b. 8 Aug 1724 d. 1 Jan 1785
7
Son Johnson
[1.4.5.4.4.2.1]
b. Abt 1754 d. 1 Jun 1754
7
David Johnson
[1.4.5.4.4.2.2]
b. 1 Jun 1754 d. 1 Jan 1785
7
Oliver Cromwell Johnson
[1.4.5.4.4.2.3]
b. 23 Mar 1757 d. 23 Apr 1816
Hannah George
b. 19 Oct 1758 d. 19 Apr 1816
8
Sally Johnson
[1.4.5.4.4.2.3.1]
b. 17 Jan 1791
William Yelverton Probart
b. 1785
9
Almyra A Probart
[1.4.5.4.4.2.3.1.1]
b. 1813 d. 1854
John Berry McFerrin
b. 15 Jun 1807 d. 10 May 1887
10
Daughter McFerrin
[1.4.5.4.4.2.3.1.1.1]
b. 1836 d. 1836
10
Sarah Jane McFerrin
[1.4.5.4.4.2.3.1.1.2]
b. 1842
James Douglas Anderson
b. 14 Oct 1824 d. 16 Mar 1902
11
John Mcferrin Anderson
[1.4.5.4.4.2.3.1.1.2.1]
b. 20 Jun 1862 d. 30 Dec 1933
11
William Wade Anderson
[1.4.5.4.4.2.3.1.1.2.2]
b. 19 May 1865 d. 18 Apr 1950
11
Douglas Anderson
[1.4.5.4.4.2.3.1.1.2.3]
b. 10 Jun 1867 d. 8 Oct 1948
11
Walter Leake Anderson
[1.4.5.4.4.2.3.1.1.2.4]
b. 4 Dec 1869 d. 9 Sep 1959
11
Ewell Avery Anderson
[1.4.5.4.4.2.3.1.1.2.5]
b. 31 Dec 1871 d. 26 Nov 1899
11
Mary Anderson
[1.4.5.4.4.2.3.1.1.2.6]
b. 1873
11
Virginia Lon Anderson
[1.4.5.4.4.2.3.1.1.2.7]
b. 1 Nov 1875 d. 22 Jun 1964
11
Dora Anderson
[1.4.5.4.4.2.3.1.1.2.8]
b. 22 Mar 1878 d. 14 Oct 1902
11
Frank Weakley Anderson
[1.4.5.4.4.2.3.1.1.2.9]
b. 30 Mar 1883
11
Janie Parish Anderson
[1.4.5.4.4.2.3.1.1.2.10]
b. 4 Oct 1886 d. 22 May 1930
10
James William McFerrin
[1.4.5.4.4.2.3.1.1.3]
b. 1846 d. Nov 1880
10
John Anderson McFerrin
[1.4.5.4.4.2.3.1.1.4]
b. Mar 1848
10
Bettie McFerrin
[1.4.5.4.4.2.3.1.1.5]
b. Abt 1850 d. Jun 1854
10
Almyra McFerrin
[1.4.5.4.4.2.3.1.1.6]
b. Abt 1854
Augustus Payton Sowell
b. 2 Mar 1849 bur. 3 Sep 1932
11
Fannie McFerrin Sowell
[1.4.5.4.4.2.3.1.1.6.1]
b. Abt 1880
8
Clarissa Harlow Johnson
[1.4.5.4.4.2.3.2]
b. 14 Feb 1789 d. 2 May 1836
Daniel Sanger
b. 3 Jul 1765 d. 10 Dec 1840
9
Joanna Sanger
[1.4.5.4.4.2.3.2.1]
b. 25 Oct 1821
Aaron Rice
b. 1816 d. 11 Mar 1888
10
Sarah Frances Rice
[1.4.5.4.4.2.3.2.1.1]
b. 1 Apr 1850
10
Clara S Rice
[1.4.5.4.4.2.3.2.1.2]
b. 27 Feb 1853
10
Alice Olivia Rice
[1.4.5.4.4.2.3.2.1.3]
b. 28 Jul 1857
+
George G Tidsbury
b. 1853
9
George Jedediah Sanger
[1.4.5.4.4.2.3.2.2]
b. 27 Aug 1826
Susan Victoria Bartholomew
b. 10 Feb 1837
10
Sarah Isabel Sanger
[1.4.5.4.4.2.3.2.2.1]
b. 1 Jan 1865
Benjamin Francis Richardson
b. 22 Aug 1863 d. 15 Feb 1916
11
George Sanger Richardson
[1.4.5.4.4.2.3.2.2.1.1]
b. 1894
10
Ruth L Sanger
[1.4.5.4.4.2.3.2.2.2]
b. 1 Jan 1865
8
Hannah Johnson
[1.4.5.4.4.2.3.3]
b. 3 Feb 1782
David Crockett Snow
b. 1791 d. 1835
9
Hannah Amanda Snow
[1.4.5.4.4.2.3.3.1]
b. Abt 1812
+
Henry M Stratton
b. 1812 d. 5 Sep 1831
9
Mary Ann Snow
[1.4.5.4.4.2.3.3.2]
b. Abt 1814
Madison Stratton
b. Abt 1813 d. 15 Dec 1898
10
Anthony M. Stratton
[1.4.5.4.4.2.3.3.2.1]
b. 1835 d. 2 Nov 1835
10
Amanda Elizabeth Stratton
[1.4.5.4.4.2.3.3.2.2]
b. Abt 1837 d. 18 Jul 1920
Hampton Johnson Cheney
b. 2 Jun 1836 d. 12 Sep 1927
11
Mary Cheney
[1.4.5.4.4.2.3.3.2.2.1]
b. 24 Sep 1865
11
Hampton Johnson Cheney
[1.4.5.4.4.2.3.3.2.2.2]
b. 5 Oct 1867
11
Lenora Cheney
[1.4.5.4.4.2.3.3.2.2.3]
b. 12 Feb 1871
11
Madeline S Cheney
[1.4.5.4.4.2.3.3.2.2.4]
b. 28 Oct 1873
10
David Thomas Stratton
[1.4.5.4.4.2.3.3.2.3]
b. 18 Dec 1838 d. 6 Nov 1896
Agnes F Taylor
b. Abt 1844
11
Sallie Stratton
[1.4.5.4.4.2.3.3.2.3.1]
b. Abt 1861
11
John Taylor Stratton
[1.4.5.4.4.2.3.3.2.3.2]
b. Abt 1867
Katie C Gray
b. 5 Mar 1867 d. 18 Nov 1934
12
Annie S Stratton
[1.4.5.4.4.2.3.3.2.3.2.1]
b. 1898
12
Mary W Stratton
[1.4.5.4.4.2.3.3.2.3.2.2]
b. 1899
11
M T Stratton
[1.4.5.4.4.2.3.3.2.3.3]
b. Abt 1869
11
Agnes Walker Stratton
[1.4.5.4.4.2.3.3.2.3.4]
b. Abt 1878
10
William Oliver Stratton
[1.4.5.4.4.2.3.3.2.4]
b. 16 Oct 1840 d. 6 Oct 1908
Elizabeth T Hall
b. Abt 1846
11
Carrie M Stratton
[1.4.5.4.4.2.3.3.2.4.1]
b. 16 Dec 1866
11
Alexander Stratton
[1.4.5.4.4.2.3.3.2.4.2]
b. Abt 1870
11
Walter M Stratton
[1.4.5.4.4.2.3.3.2.4.3]
b. 1873
Elizabeth Trevin
b. 1876
12
Nell Stratton
[1.4.5.4.4.2.3.3.2.4.3.1]
b. 1901
11
Frank William Stratton
[1.4.5.4.4.2.3.3.2.4.4]
b. Aug 1874 d. 9 Jun 1896
Davie Lou Pursley
b. Oct 1875
12
Carrie Hall Stratton
[1.4.5.4.4.2.3.3.2.4.4.1]
b. 22 Sep 1898 d. 5 Aug 1977 [
=>
]
12
Susie B Stratton
[1.4.5.4.4.2.3.3.2.4.4.2]
b. 1901 d. 2000
12
William P Stratton
[1.4.5.4.4.2.3.3.2.4.4.3]
b. 1903 d. Feb 1974
12
Nina Stratton
[1.4.5.4.4.2.3.3.2.4.4.4]
b. 1904 d. Apr 1987
10
Catherine Stratton
[1.4.5.4.4.2.3.3.2.5]
b. Abt 1844
10
Madison Stratton
[1.4.5.4.4.2.3.3.2.6]
b. Abt 1846
+
Ella A McKennie
b. Abt 1846
10
George Stratton
[1.4.5.4.4.2.3.3.2.7]
b. Abt 1849
+
Louise L Lanier
b. 1850
10
Benjamin Franklin Stratton
[1.4.5.4.4.2.3.3.2.8]
b. 1853
Mary Elizabeth Garrett
b. Oct 1862
11
Mary Margaret Stratton
[1.4.5.4.4.2.3.3.2.8.1]
b. 4 Oct 1884
9
Oliver William Snow
[1.4.5.4.4.2.3.3.3]
b. Abt 1816
9
Anthony J Snow
[1.4.5.4.4.2.3.3.4]
b. 1819 d. 1 Jun 1853
Catherine Stratton
b. 18 Feb 1818 d. Aft 1851
10
James Snow
[1.4.5.4.4.2.3.3.4.1]
b. 1842
Laura
b. 1846
11
Kaley Snow
[1.4.5.4.4.2.3.3.4.1.1]
b. 1869
11
Lula Snow
[1.4.5.4.4.2.3.3.4.1.2]
b. 1874
10
Susan E Snow
[1.4.5.4.4.2.3.3.4.2]
b. 1844
Marcellus M Gee
b. 1842
11
Kate Gee
[1.4.5.4.4.2.3.3.4.2.1]
b. 1866
11
Jennie Gee
[1.4.5.4.4.2.3.3.4.2.2]
b. 1868
10
Mary Snow
[1.4.5.4.4.2.3.3.4.3]
b. 1846
Thomas O Morris
b. 2 Aug 1845 d. 8 Nov 1924
11
Henry Snow Morris
[1.4.5.4.4.2.3.3.4.3.1]
b. 1867
Mary Emma Lackey
b. 1874
12
Thomas O Morris
[1.4.5.4.4.2.3.3.4.3.1.1]
b. 1898
12
James L Morris
[1.4.5.4.4.2.3.3.4.3.1.2]
b. 1902 d. Jan 1973
11
Edwin Lanier Morris
[1.4.5.4.4.2.3.3.4.3.2]
b. 1869
+
Annie M
b. Apr 1869
11
Thomas O Morris, Jr
[1.4.5.4.4.2.3.3.4.3.3]
b. 1872
11
Katherine Morris
[1.4.5.4.4.2.3.3.4.3.4]
b. 1873
11
Kindred Jackson Morris
[1.4.5.4.4.2.3.3.4.3.5]
b. 1875
10
Thomas A Snow
[1.4.5.4.4.2.3.3.4.4]
b. 1850
Susan W Graves
b. Jun 1852 d. 2 Jan 1930
11
Nina Elizabeth Snow
[1.4.5.4.4.2.3.3.4.4.1]
b. 17 Jan 1881 d. 8 May 1974
+
James Leonidas Foust
b. 9 Dec 1867 d. 1944
10
Jennie Snow
[1.4.5.4.4.2.3.3.4.5]
b. 1851
8
Elizabeth Johnson
[1.4.5.4.4.2.3.4]
b. 2 Jul 1783
Isaac Fiske
b. 26 May 1782 d. 3 Dec 1846
9
Moses Madison Fiske
[1.4.5.4.4.2.3.4.1]
b. Abt 1804 d. 5 Feb 1888
Harriet Herring
b. 21 Jan 1807 d. 10 May 1893
10
George Herring Fiske
[1.4.5.4.4.2.3.4.1.1]
b. 26 Feb 1832 d. 5 Dec 1895
Angie W Annett
b. 1832 d. Aft May 1872
11
Effie Fiske
[1.4.5.4.4.2.3.4.1.1.1]
b. 25 Jan 1861 d. Aft Jan 1894
Arthur H Lawrence
b. 24 Nov 1856
12
Ella May Lawrence
[1.4.5.4.4.2.3.4.1.1.1.1]
b. 23 Dec 1885
12
William Arthur Lawrence
[1.4.5.4.4.2.3.4.1.1.1.2]
b. 26 Apr 1887
12
Edith Willena Lawrence
[1.4.5.4.4.2.3.4.1.1.1.3]
b. 2 Jul 1890
12
Edward Wells Lawrence
[1.4.5.4.4.2.3.4.1.1.1.4]
b. 17 Jun 1892
12
Harold Fisk Lawrence
[1.4.5.4.4.2.3.4.1.1.1.5]
b. 21 Jan 1894
11
S Wilbur Fiske
[1.4.5.4.4.2.3.4.1.1.2]
b. 1 May 1872
10
Winslow Johnson Fiske
[1.4.5.4.4.2.3.4.1.2]
b. 18 Feb 1834 d. 14 Jan 1894
10
Harriet Augusta Fiske
[1.4.5.4.4.2.3.4.1.3]
b. 29 May 1836 d. Bef 1940
10
Captain John Murray Fiske
[1.4.5.4.4.2.3.4.1.4]
b. 28 Sep 1838 d. 3 May 1896
10
Marie Antionette Fiske
[1.4.5.4.4.2.3.4.1.5]
b. 1840 d. Aft 1870
10
Ellen Louisa Fiske
[1.4.5.4.4.2.3.4.1.6]
b. 6 May 1843 d. 6 Jun 1868
10
Andrew J Fiske
[1.4.5.4.4.2.3.4.1.7]
b. 8 Jun 1845 d. 5 Mar 1895
10
Seth Herring Fiske
[1.4.5.4.4.2.3.4.1.8]
b. 11 Apr 1848 d. 5 Sep 1870
9
Oliver J Fiske
[1.4.5.4.4.2.3.4.2]
b. Abt 1805 d. 8 Jan 1886
9
Charles C Fiske
[1.4.5.4.4.2.3.4.3]
b. 23 Feb 1807
9
Thomas Fiske
[1.4.5.4.4.2.3.4.4]
b. Abt 1809 d. Jan 1893
9
Ebenezer W Fiske
[1.4.5.4.4.2.3.4.5]
b. Abt 1812 d. 27 Aug 1883
8
Parthena Johnson
[1.4.5.4.4.2.3.5]
b. 8 Aug 1785 d. 25 Jan 1820
8
Gabrilla Johnson
[1.4.5.4.4.2.3.6]
b. 27 Feb 1786 d. 11 Jan 1867
8
Frances Fanny Johnson
[1.4.5.4.4.2.3.7]
b. Abt 1789
8
Oliver C Johnson
[1.4.5.4.4.2.3.8]
b. 29 Apr 1792
8
Windlow Penkard Johnson
[1.4.5.4.4.2.3.9]
b. 22 Mar 1794
8
Hannah Johnson
[1.4.5.4.4.2.3.10]
b. Abt 1795
8
Anthony Wayne Johnson
[1.4.5.4.4.2.3.11]
b. 10 Jul 1797 d. 15 May 1888
7
Mary Johnson
[1.4.5.4.4.2.4]
b. 11 Oct 1761 d. 1813
7
Jedediah Johnson
[1.4.5.4.4.2.5]
b. 1767
7
Ziba Johnson
[1.4.5.4.4.2.6]
b. 11 Apr 1770 d. 19 Sep 1843
6
Mary Packard
[1.4.5.4.4.3]
b. 1729 d. 3 Apr 1764
6
Judith Packard
[1.4.5.4.4.4]
b. Abt 1731
6
Edward Packard
[1.4.5.4.4.5]
b. 1733 d. 1806
6
Susanna Packard
[1.4.5.4.4.6]
b. 24 Aug 1736 d. 15 Dec 1818
6
John Packard
[1.4.5.4.4.7]
b. 13 Sep 1741
5
Edward Mitchell
[1.4.5.4.5]
b. 4 Jul 1705 d. 1706
5
Elizabeth Mitchell
[1.4.5.4.6]
b. 12 May 1710 d. Abt 1711
5
Mary Mitchell
[1.4.5.4.7]
b. 11 May 1713
5
Seth Mitchell
[1.4.5.4.8]
b. 2 Oct 1715 d. 9 Dec 1802
4
Deliverance Kingman
[1.4.5.5]
b. 12 Mar 1676 d. 10 Jan 1697
4
Susanna Kingman
[1.4.5.6]
b. Mar 1678 d. 23 Jun 1776
4
Lydia Deliverence Kingman
[1.4.5.7]
b. 12 Apr 1679 d. 15 Nov 1720
3
Alice Kingman
[1.4.6]
b. 7 Jun 1635 d. Bef 24 May 1667
3
Henry Kingman
[1.4.7]
b. Abt 1636
3
Bridget Kinsman
[1.4.8]
b. Abt 1638
2
Thomas Drake
[1.5]
c. 17 Jul 1600
2
Jane Drake
[1.6]
c. 8 Aug 1601
2
Richard Drake
[1.7]
c. 9 Jan 1602